logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 76

12 janvier 2015

SOMMAIRE

Adelca Invest  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3610

Appleton S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3611

ARISTEA SICAV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3612

ATMAN SICAV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3613

ATMAN SICAV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3612

Banque Degroof Luxembourg S.A.  . . . . . .

3609

Belmilk S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3603

Bluebird Securities S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

3609

CARRON S.A., société de gestion de patri-

moine familial  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3632

C & I Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3602

Cosbet Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3611

Danube Bidco S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3648

DZBP II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3611

European Responsible Fund  . . . . . . . . . . . . .

3603

Europe Logistics Venture 1  . . . . . . . . . . . . .

3610

Extreme Growth Fund SICAV-SIF . . . . . . .

3626

Ganador  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3610

Garganey Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3606

Haus + Technik s.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3630

Merym S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3642

Nascent Group S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3608

Nobileo S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3608

OCM Luxembourg POF IV A S.à r.l.  . . . . .

3607

Office Lease Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

3607

Palladio S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3642

Petercam L Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3602

Procom-Immobilière S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

3633

ProLogis European Properties Fund II  . . .

3610

Prologis Targeted Europe Logistics Fund

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3610

Pro-Vision SD S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3633

Pro-Vision SD S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3633

Pub.K Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

3605

Radical Euro-Services S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

3646

ROLLINGER Toiture  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3633

Rollinvest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3633

SA2M  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3611

Sairam Shipping S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3605

Salon de Coiffure Tendrelle, société à res-

ponsabilité limitée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3606

Samor S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3607

Silinf S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3605

Silverton Properties S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

3629

Smart Solutions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3606

S.V.M. S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3606

Symbiotics SICAV (Lux.)  . . . . . . . . . . . . . . .

3604

T-C Neptune Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

3608

Textiles Meyer S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3626

Tishman Speyer Lumiere Holdings I S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3627

UBM CP Holdings No 4 S.à.r.l  . . . . . . . . . . .

3636

Uewen & Feier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3630

Zamataimmo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3609

Zermatt S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3609

ZIA S.A., société de gestion de patrimoine

familial  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3607

3601

L

U X E M B O U R G

C & I Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 163.943.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 décembre 2014.

Référence de publication: 2014199928/10.
(140224005) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2014.

Petercam L Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 27.128.

Petercam L Fund (la «SICAV») invite, par la présente, ses actionnaires à participer à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

(ci-après l'«AGE») qui se tiendra le <i>30 janvier 2015 , à 11 heures 00 au siège social de la SICAV, allée Scheffer 5, L-2520

Luxembourg.

Le conseil d'administration de la SICAV (le «Conseil d'Administration») a décidé de soumettre aux actionnaires de la

SICAV les modifications statutaires présentées ci-après. Ces modifications ont essentiellement pour objet de mettre en
conformité les statuts de la SICAV avec une série d'exigences réglementaires imposée par (i) la Loi du 28 juillet 2014
relative à l'immobilisation des actions et titres au porteur (la «Loi Immobilisation»); et (ii) la réglementation fiscale amé-
ricaine ‘Foreign Account Tax Compliance Act’ (‘FATCA’) qui introduit un nouveau régime d'échange d'informations et
de retenue à la source. Certaines modifications ont pour unique but de reformuler certaines clauses à des fins de clari-
fication ou de cohérence.

<i>Ordre du jour:

1. Modification de l'article 7 (Forme des actions) pour tenir compte des contraintes imposées par FATCA et pour

organiser, compte tenu des impacts de la Loi Immobilisation, une conversion des actions au porteur en actions
nominatives ou dématérialisées, un rachat ou une immobilisation desdites actions. L'article prévoit également que
la SICAV procèdera à l'annulation des actions au porteur qui n'auraient pas été converties, rachetées ou immobi-
lisées le 17 février 2016 au plus tard. Il prévoit en outre que la SICAV pourra, dès le 18 février 2016, convertir les
actions au porteur immobilisées en actions nominatives ou dématérialisées. Enfin, l'article est modifié pour refléter
notamment le fait que les droits de vote attachés aux actions au porteur qui n'auraient pas été converties, rachetées
ou immobilisées le 17 février 2015 (au plus tard) sont automatiquement suspendus et que les droits afférents aux
actions au porteur, après cette date, ne peuvent plus être exercés qu'après que lesdites actions aient été dûment
immobilisées.

2. Modification de l'article 12 (Restrictions à la propriété des actions) pour le mettre en conformité avec les exigences

réglementaires FATCA.

3. Modification de l'article 7 (Forme des actions) pour permettre à la SICAV d'émettre des titres sous forme déma-

térialisée et ajustement des articles 11 (Transfert des actions) et 12 (Restrictions à la propriété des actions) en
conséquence.

4. Modifications diverses à des fins de clarification et/ou de cohérence générale.

<i>PARTICIPATION A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

L'AGE ne délibérera valablement que si la moitié au moins du capital social est présente ou représentée (quorum) et

les résolutions devront réunir deux tiers des voix exprimées. Si le quorum n'est pas atteint, une seconde assemblée
générale extraordinaire des actionnaires sera convoquée. Celle-ci pourra valablement se tenir sans quorum minimum,
étant entendu que les résolutions devront toujours réunir les deux tiers des voix exprimées.

Une brochure explicative, reprenant les raisons des modifications proposées ainsi que les modalités de participation

à la présente AGE, est disponible, sans frais et sur simple demande, au siège social de la SICAV (dont les coordonnées
sont reprises plus haut).

Les formulaires de vote et de procuration ainsi que le projet de texte des statuts coordonnés sont disponibles au siège

social de la SICAV et peuvent être obtenus, sans frais, sur simple demande.

Référence de publication: 2015002774/44.

3602

L

U X E M B O U R G

Belmilk S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 59, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 82.963.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2014199899/9.

(140223690) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2014.

European Responsible Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 90.502.

As the quorum could not be reached at the extraordinary general meeting of shareholders of the Company which

took place on 6 January 2015, we are pleased to convene shareholders to the

SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of shareholders of the Company (the Meeting) that will be held at the registered office of the Company on <i>11 February

<i>2015 at 10:00 a.m. (Luxembourg time) with the following agenda:

<i>Agenda:

I. To propose the modification of the Articles of Incorporation (the “Articles”) as follows:

1. Change of the name of the Company from “EUROPEAN RESPONSIBLE FUND” into “LUX GLOBAL FUND -

SICAV” and modification of Article 1 accordingly;

2. Choice of English as the official language of the Articles as authorised by article 26 (2) of the law of 17 December

2010 on undertakings for collective investment (the “2010 Law”);

3. Replacement of all references in the Articles to the law of 20 December 2002 by references to the 2010 Law;
4. Remove all references in the Articles to bearer shares or holders of bearer shares;
5. Amendment of Article 11 and Article 16 regarding the possibility to set-up of a master-feeder structure, to allow

the convening of the annual general meeting of shareholders at another date, time and place as set forth in the
Articles, to also provide for the possibility to fix a record date by reference to which attendance rights, quorum
and majority requirements for shareholders' meetings will be measured, to allow cross-sub-funds investments and
update the provisions relating to mergers of sub-funds or of the Company;

6. Amendment of Article 17 whereby to include the ESAF group and any branches or affiliate company of it into the

scope of the Article;

7. Amend Article 21 by providing for the possibility for the Fund if redemption requests made pursuant to this Article

21 exceed a certain threshold determined by the Board of Directors regarding the number of shares outstanding,
the Board of Directors may decide that all or some of these redemption requests shall be deferred for the time
required to make the assets available to satisfy such requests. After this period, in relation to the other valuation
day in question, these redemption and conversion requests shall be treated as priority over future requests;

8. Amend Article 22 to add the following condition to the suspension of the calculation of the net value of shares,

issuance and redemption of shares: (i) when there is a suspension of the calculation of the net asset value of a
UCITS and other UCIs in which one or more compartments have invested a significant portion of their assets, if
the value of this investment cannot be reasonably determined; (ii) upon notice of a meeting of shareholders at
which the dissolution of the Company will be proposed; (iii) at any time from the publication of a convening notice
to a general meeting of shareholders announcing the merger of the Company or of one or several compartments
of the Company, or upon decision of the Board of Directors to merge one or more compartments of the Company
has been given, to the extent where such suspension is justified to protect the interests of the shareholders;

9. Amendment of Article 27 to provide for the possibility to liquidate the Company at the decision of the Board of

Directors if imposed by reasons of economic rationalization;

10. Insert Article 28 in accordance with Art. 66 (4) of the 2010 Law.

Decisions on all items of the agenda require no quorum of presence and may validly be passed by the affirmative vote

of at least two thirds of the votes validly cast at the Meeting. Each share is entitled to one vote. Proxies are available at
the registered office of the Company.

Référence de publication: 2015004204/755/45.

3603

L

U X E M B O U R G

Symbiotics SICAV (Lux.), Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spé-

cialisé.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 169.830.

As the extraordinary general meeting of shareholders of the Sicav held on 29 December 2014 (the “First EGM”) could

not validly deliberate on the agenda for lack of quorum, shareholders are hereby reconvened to assist at a

RECONVENED EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of Shareholders (the “Reconvened EGM”) of the Sicav which will be held at the registered office of the Sicav on <i>February

<i>13, 2015

 , at 11:00 a.m. (Luxembourg time), with the following agenda:

<i>Agenda:

1. To insert a new article 9 of the articles of incorporation (the “Articles”) to permit the Board of Directors to issue

parts bénéficiaires in accordance with the sales documents and consequent amendment to articles 10 and 23 (former
9 and 22) of the Articles.

2. To amend article 11 (former article 10) of the Articles to permit the Board of Directors to redeem shares of a

Sub-fund in order to make a distribution. Such redemption shall be made under the conditions and at the price set
forth in the sales documents of the Sicav.

3. To amend article 16 (former article 15) of the Articles to add that the Sicav may act as an internally managed

alternative investment fund in the meaning of the law of 12 July 2013 on alternative investment fund managers (the
“AIFM Law”) or appoint another entity as designated AIFM of the Company.

4. To amend article 27 (former article 26) of the Articles in order to allow distributions to be made in accordance

with the provisions set forth in the sales documents of the Sicav under the form of redemption of shares, dividends
or otherwise, as determined by the Board.

5. To replace any reference to the Custodian by reference to the Depositary under article 30 (former article 29) of

the Articles and update the responsibilities and liabilities of the Depositary towards the Sicav.

6. To insert a new article 31 of the Articles defining the preferential treatment of investors.
7. To insert a new article 32 of the Articles related to investors' information
8. To delete or update any outdated or redundant information and to clarify the Sicav's position where appropriate

on the Articles.

Shareholders' attention is drawn to the fact that the agenda set out in the notice of the First EGM contained typos as

to numbering of articles so that item 1 should have read “insert a new article 9” and contained reference to amendments
to articles 10 and 23 and articles renumbered throughout the other items of the agenda. This does not impact the
contemplated amendments proposed to the vote on the First EGM.

The full text of the proposed statutory modifications can be obtained free of charge on request made at the Sicav's

registered office. For the avoidance of doubt, despite the minor corrections to the agenda as described above, the full
text of the proposed statutory modifications remains unchanged since the First EGM.

The Reconvened EGM will validly deliberate on all items of the agenda, without any quorum requirement. The reso-

lution will be taken at a majority of two thirds of the votes cast. Each share is entitled to one vote.

The quorum and the majority at the Reconvened EGM will be determined according to the shares issued and out-

standing at midnight (Luxembourg time) on the fifth day prior to the Reconvened EGM, i.e. February 8, 2015 (the “Record
Date”). The rights of a shareholder to attend the Reconvened EGM and to exercise a voting right attaching to his/her/its
shares are determined in accordance with the shares held by this shareholder at the Record Date.

Shareholders who will not be able to attend the Reconvened EGM may vote by proxy by returning the proxy form

which is available at the registered office of the SICAV, duly completed and signed, to the attention of: Julien BOUCHEZ
by mail and/or by fax at the number +352 47 67 84 07 and/or by e-mail at lb-domicile@caceis.com before February 12,
2015 at midnight CET. Forms of proxy already received for the First EGM held on 29 December 2014 will be valid at the
Reconvened EGM with the agenda set forth above.

Should shareholders or their proxy wish to take part in the Reconvened EGM, shareholders are kindly requested to

inform the Sicav at least two clear days prior to the holding of the Reconvened EGM of their intention to attend. Share-
holders,  respectively  their  proxy  shall  be  admitted  subject  to  verification  of  their  identity  and  evidence  of  their
shareholding.

<i>By the Board of Directors.

Référence de publication: 2015004203/755/54.

3604

L

U X E M B O U R G

Pub.K Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1326 Luxembourg, 32, rue Auguste Charles.

R.C.S. Luxembourg B 60.496.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue au siège de la société extraordinairement en date du 12 décembre

<i>2014 à 16.00 heures

L'assemblée générale regrette le décès de Monsieur Pierre LEFRANCOIS, administrateur de la société.
L'assemblée générale nomme en remplacement jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2015, Monsieur

Quentin LEFRANCOIS, né à Strasbourg (F) le 09.03.1996, demeurant à F - 67530 Boersch, 20, Rue des Muguets.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Un administrateur

Référence de publication: 2014199533/14.
(140222404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2014.

Silinf S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 82.255.

<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration en date du 12 décembre 2014

Est nommé administrateur, en remplacement de Monsieur Luc HANSEN, administrateur démissionnaire:
- Monsieur Marc ALBERTUS, employé privé, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653

Luxembourg.

Monsieur Marc ALBERTUS terminera le mandat de l'administrateur démissionnaire qui viendra à échéance lors de

l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2013.

Cette cooptation sera soumise à ratification par la prochaine assemblée générale.
Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 12 décembre 2014.

Référence de publication: 2014200595/16.
(140223458) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2014.

Sairam Shipping S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 24, rue Astrid.

R.C.S. Luxembourg B 97.300.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires réunie au Luxembourg, le 14

<i>novembre 2014 à 10.00 heures.

<i>Première résolution

Acceptation de la démission du Commissaire aux Comptes:
A3T S.A. R.C.S. Luxembourg B 158.687 ayant pour adresse professionnelle 44, boulevard Grande-Duchesse Charlotte

à L-1330 Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

Nomination en remplacement du Commissaire aux Comptes:
FIDUCIARY TUCCI &amp; PARTNERS S.A., R.C.S. Luxembourg B 177.770, 10A, rue Henri Schnadt (bureau 4a), L-2530

Luxembourg,

Le mandat du nouveau Commissaire aux Comptes prendra fin à l'Assemblée Générale Ordinaire statutaire de l'an

2015.

<i>Troisième résolution

Etablissement du nouveau siège social de la société au L-1143 Luxembourg, 24, rue Astrid.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014199591/24.
(140222624) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2014.

3605

L

U X E M B O U R G

Smart Solutions, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1321 Luxembourg, 43, rue de Cessange.

R.C.S. Luxembourg B 160.846.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

12, RUE DE BITBOURG L-1273 LUXEMBOURG

Référence de publication: 2014200553/10.
(140224428) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2014.

Salon de Coiffure Tendrelle, société à responsabilité limitée, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4025 Esch-sur-Alzette, 40, rue de Belvaux.

R.C.S. Luxembourg B 22.044.

Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Mandataire

Référence de publication: 2014200574/10.
(140224133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2014.

Garganey Sàrl, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 138.983.

Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 décembre 2014.

Luxembourg Corporation Company S.A.
Signatures
<i>Gérant unique

Référence de publication: 2014201617/13.
(140225724) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2014.

S.V.M. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-3817 Schifflange, Chemin de Bergem.

R.C.S. Luxembourg B 42.790.

EXTRAIT

Suivant la convention de cession de parts sociales conclue sous seing privé en date du 13 juillet 2011, il résulte que le

capital social de la Société est désormais réparti comme suit:

- La société COSTANTINI GROUP S.A., ayant son siège social à L-3441 Dudelange, 23, avenue
Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 134286 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

375 parts sociales

- Monsieur Charles FEYEREISEN, fonctionnaire, demeurant à L-2670 Luxembourg, 36, Boulevard
de Verdun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

375 parts sociales

- La société GOLDCORP S.à r.l., ayant son siège social au 128, Boulevard de la Pétrusse L - 2330
Luxembourg, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 142029 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250 parts sociales

TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 parts sociales

Pour extrait conforme,

Schifflange, le 13 juillet 2011.

Référence de publication: 2014200545/21.
(140223695) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2014.

3606

L

U X E M B O U R G

OCM Luxembourg POF IV A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 131.099.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 décembre 2014.

Référence de publication: 2014201898/10.
(140225813) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2014.

Office Lease Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7553 Mersch, 8, rue J.B. Neuens.

R.C.S. Luxembourg B 123.396.

Les comptes annuels au 30 septembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014201899/10.
(140225627) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2014.

ZIA S.A., société de gestion de patrimoine familial, Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 157.916.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 décembre 2014.

<i>Pour: ZIA S.A., société de gestion de patrimoine familial
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme

Référence de publication: 2014202129/14.
(140226074) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2014.

Samor S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, rives de Clausen.

R.C.S. Luxembourg B 60.063.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 15 décembre 2014

que les mandats suivants ont été renouvelés:

- Monsieur Roberto AMODEI, à la fonction d'administrateur de classe A
- Monsieur Raffaello ROSSI, à la fonction d'administrateur de classe A
- Monsieur Alex SCHMITT, à la fonction d'administrateur de classe B
- Monsieur Lionel NOGUERA, à la fonction d'administrateur de classe B
- Monsieur Lex BENOY, à la fonction de commissaire aux comptes
Monsieur Roberto AMODEI, actuel administrateur a été nommé Président du Conseil d'administration
Les mandats des administrateurs de classe A, des administrateurs de classe B et du commissaire aux comptes viendront

à échéance lors de l'Assemblée générale qui se tiendra en 2020.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 15 décembre 2014.

Référence de publication: 2014200575/20.
(140224105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2014.

3607

L

U X E M B O U R G

Nobileo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 109.659.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 Décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 Décembre 2014.

Nobileo S.à r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
<i>Manager

Référence de publication: 2014201877/14.
(140225587) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2014.

Nascent Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 77.159.

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-

Duché de Luxembourg), en date du 27 juillet 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°
15 du 10 janvier 2001.

Les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Nascent Group S.A. en liquidation volontaire
Signature

Référence de publication: 2014201863/15.
(140226230) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2014.

T-C Neptune Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2530 Gasperich, 4a, rue Henri Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 192.184.

EXTRAIT

L'associé de la Société, Luxembourg Investment Company 12 S.à r.l., a changé sa dénomination en date du 5 décembre

2014 et s'appelle dorénavant TIAA Luxembourg S.à r.l.

Par résolutions écrites prises en date du 15 décembre 2014, les associés de la Société ont décidé:
1. d'accepter, avec effet immédiat, la démission de Madame Sinead Mary Browne en tant que gérante de la Société;
2. de nommer les personnes suivantes en tant que nouveaux gérants de la Société pour une période illimitée et avec

effet immédiat:

- Robert John Redican, résidant au 8625 Andrew Carnegie Blvd, E1 N5 Charlotte, NC 28262, Etats-Unis d'Amérique;
- Willem-Arnoud Gijsbert Van Rooyen, résidant professionnellement au 7a, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg,

Grand Duché de Luxembourg;

- Suman Gera, résidant professionnellement au 8500 Andrew Carnegie Blvd, 3rd Floor, Charlotte, NC - 28262, Etats-

Unis d'Amérique;

- Bruno Bagnouls, résidant professionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duché de

Luxembourg; et

- Karl Heinz Dick, résidant professionnellement au 53, Tontelerwee, L-8552 Operpallen, Grand Duché de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour T-C Neptune Holdings S.à r.l.

Référence de publication: 2014200630/25.
(140224104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2014.

3608

L

U X E M B O U R G

Zamataimmo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 2A, rue des Capucins.

R.C.S. Luxembourg B 31.423.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014200707/9.
(140224123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2014.

Zermatt S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 136.231.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014200709/9.
(140223872) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2014.

Banque Degroof Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 25.459.

<i>Extrait des décisions du conseil d'administration du 5 décembre 2014

Il résulte des délibérations et décisions du Conseil d'administration tenu au siège social le 5 décembre 2014 que:
Le Conseil d'Administration, conformément à la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts

au porteur et à la tenue du registre des actions nominatives et du registre des actions au porteur, décide de nommer
Banque Degroof Luxembourg S.A. comme dépositaire des actions au porteur émises par Banque Degroof Luxembourg
S.A.

Luxembourg, le 15 décembre 2014.

BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
Geert De Bruyne
<i>Administrateur-Délégué

Référence de publication: 2014199890/17.
(140224079) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2014.

Bluebird Securities S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 124.209.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire de la société en date du 12 décembre 2014

<i>(l' «Assemblée»)

L'Assemblée accepte la démission de Martijn Sinninghe Damsté en tant qu'administrateur de la Société avec effet au

14 décembre 2014.

L'Assemblée décide de nommer la personne suivante en tant que nouvel administrateur de la Société avec effet 15

décembre 2014 et ce jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2016:

- Caroline Kinyua née le 22 Février 1978 à Nairobi, Kenya, avec adresse professionnelle au 9B, Boulevard Prince Henri,

L-1724 Luxembourg,

À Luxembourg, le 12 décembre 2014.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>L'agent domiciliataire

Référence de publication: 2014199878/19.
(140224097) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2014.

3609

L

U X E M B O U R G

Ganador, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Axxion S.A. / Banque de Luxembourg S.A.
Unterschriften
<i>Verwaltungsgesellschaft / Verwahrstelle

Référence de publication: 2014185334/10.
(140209392) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2014.

Adelca Invest, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Axxion S.A. / Banque de Luxembourg
<i>Verwaltungsgesellschaft / <i>Verwahrstelle
Unterschriften / Unterschriften

Référence de publication: 2014185335/10.
(140209393) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2014.

Europe Logistics Venture 1, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé.

EXTRAIT

Le règlement de gestion de Europe Logistics Venture 1 daté du 22 décembre 2014 a été déposé au registre de com-

merce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 décembre 2014.

<i>Pour la Société

Référence de publication: 2015000542/11.
(140235542) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2014.

ProLogis European Properties Fund II, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé.

EXTRAIT

Le règlement de gestion de ProLogis European Properties Fund II daté du 22 décembre 2014 a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 décembre 2014.

<i>Pour la Société

Référence de publication: 2015000541/11.
(140235541) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2014.

Prologis Targeted Europe Logistics Fund, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spé-

cialisé.

EXTRAIT

Le règlement de gestion de Prologis Targeted Europe Logistics Fund daté du 22 décembre 2014 a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 décembre 2014.

<i>Pour la Société

Référence de publication: 2015000540/12.
(140235475) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2014.

3610

L

U X E M B O U R G

SA2M, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du Dix Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 159.423.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014200581/9.
(140223616) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2014.

DZBP II, Fonds Commun de Placement.

Das koordinierte Verwaltungsreglement, in Kraft getreten am 10. Dezember 2014, wurde beim Handels- und Gesell-

schaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, im Dezember 2014.

IPConcept (Luxemburg) S.A.

Référence de publication: 2014195095/10.
(140218056) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2014.

Appleton S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 131.102.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

La liquidation de la société Appleton S.à r.l, décidée par acte auprès du notaire Maître Jean Seckler, en date du 28

novembre 2014, a été clôturée lors de l'assemblée générale extraordinaire sous seing privé tenue en date du 15 décembre
2014.

Les livres et documents de la société seront conservés pendant cinq ans au 26A, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 décembre 2014.

Vanessa Lorreyte
<i>Le Mandataire

Référence de publication: 2014199823/17.
(140223561) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2014.

Cosbet Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 146.283.

Il résulte des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire de la société en date du 15 décembre 2014 que:
- Le siège social de la société a été transféré au 1, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg avec effet au 15 décembre

2014;

- Monsieur Ismail Waseem, né le 5 janvier 1959 à Malé (Maldives) et demeurant Block 20074, Ever Chance, Kashimaa

Hingun, Malé, Maldives, est nommé administrateur unique de la société avec effet immédiat et ce pour une durée de six
ans;

- La société ODD Financial Services S.A., ayant son siège social 1 -3, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, RCS

Luxembourg B 41014, est nommée commissaire aux comptes de la société avec effet immédiat et ce pour une durée de
six ans.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 15 décembre 2014.

Référence de publication: 2014199998/18.
(140224355) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2014.

3611

L

U X E M B O U R G

ARISTEA SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable,

(anc. ATMAN SICAV).

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 193.297.

In the year two thousand fourteen, on the twenty-second of December.
Before us Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg.

Was held

an extraordinary general meeting of the shareholders of ATMAN SICAV, société d’investissement à capital variable,

with registered office at 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, incorporated by a deed of the undersigned notary, on
December 4, 2014, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.

The meeting is opened, Mrs. Arlette Siebenaler, residing professionally in Luxembourg is elected chairman of the

meeting.

Mrs Annick Braquet, residing professionally in Luxembourg is appointed scrutineer.
The chairman and the scrutineer agreed that Mrs Annick Braquet, residing professionally in Luxembourg, is appointed

to assume the role of secretary.

The chairman then declared and requested the notary to declare the following:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance

list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies
will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

II.- It appears from the attendance list, that all shares in circulation are present or represented at the present ex-

traordinary general meeting, so that the meeting could validly decide on all the items of the agenda.

IV.- That the agenda of the present meeting is the following:

<i>Agenda

1. Modify the name of the Company into ARISTEA SICAV and subsequent amendment of article 1 of the articles of

incorporation.

2. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting decides to modify the name of the Company into ARISTEA SICAV and to amend article 1 of the

articles of incorporation as follows:

“ Art. 1. Name. There exists among the subscribers and all those who may become holders of Shares, a company in

the form of a public limited company (société anonyme) qualifying as an investment company with variable share capital
(société d'investissement à capital variable) under the name of "ARISTEA SICAV" (the "Fund").”

There being no further business before the meeting, the same was thereupon closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing

party, the present deed is worded in English.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this do-

cument.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.
Signé: A. SIEBENALER, A. BRAQUET et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 22 décembre 2014. Relation: LAC/2014/62302. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 6 janvier 2015.

Référence de publication: 2015002036/49.
(150002024) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2015.

3612

L

U X E M B O U R G

ATMAN SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 193.297.

STATUTES

In the year two thousand fourteen, on the fourth of December.
Before the undersigned Maître Henri Hellinckx, Notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

BANOR SIM S.P.A., having its registered office in Via Santa Radegonda II, 20121, Milano, Italy,
here represented by Mr. Philippe Zamperini, with professional address in 41, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal.
The said proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the Notary, will remain annexed to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in their hereabove stated capacities, has required the notary to enact the deed of incor-

poration  of  a  Luxembourg  public  limited  company  (société  anonyme)  with  variable  capital,  qualifying  as  a  société
d’investissement à capital variable (SICAV), which it declares organized and the articles of incorporation of which (the
“Articles of Incorporation”) shall be as follows:

Art. 1. Name. There exists among the subscribers and all those who may become holders of Shares, a company in the

form of a public limited company (société anonyme) qualifying as an investment company with variable share capital
(société d'investissement à capital variable) under the name of "ATMAN SICAV" (the "Fund").

Art. 2. Duration. The Fund is established for an unlimited period of time. It may be dissolved at any moment by a

Shareholders decision of the general meeting adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incor-
poration.

Art. 3. Object. The exclusive object of the Fund is to place the funds available to it in transferable securities of all types

and all other permitted assets such as those referred to in Part I of the Law of 17 December 2010 regarding undertakings
for collective investment or any legislative replacements or amendments thereof (the “2010 Law”) with the purpose of
spreading investment risks and affording its Shareholders the results of the management of its assets.

The Fund may take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and

development of its purpose to the full extent permitted by the 2010 Law.

Art. 4. Registered office. The registered office of the Fund is established in Luxembourg-City, in the Grand-Duchy of

Luxembourg. Wholly owned subsidiaries, branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad
by resolution of the Board of directors.

In the event that the Board of directors determines that extraordinary political, military, economic or social develop-

ments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Fund at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Fund which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain
a Luxembourg fund.

Art. 5. Share Capital. The capital of the Fund shall be represented by Shares of no par value and shall at any time be

equal to the total net assets of the Fund as defined in Article 22 hereof.

The initial capital comes to thirty-one thousand Euro (EUR 31,000), divided into thirty-one (310) fully paid-up shares

of no par value.

The minimum capital of the Fund shall be the minimum prescribed by Luxembourg law.
The Board of directors is authorized without limitation to issue further Shares to be fully paid at any time at the net

asset value per share or at the respective net asset value per share determined in accordance with Article 22 hereof
without reserving the existing Shareholders a preferential right to subscription of the Shares to be issued.

The Board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the Fund or to any other duly

authorized person, the duty of accepting subscriptions for delivering and receiving payment for such new Shares.

Art. 6. Form of shares. The Board of directors may establish a portfolio of assets constituting a Sub-Fund within the

meaning of Article 181 of the 2010 Law, and the proceeds of the issuance of each Sub-Fund shall be invested in transferable
securities of any kind and other assets permitted by law corresponding to such geographical areas, industrial sectors or
monetary zones, or to such specific types of equity or debt securities, or/and with such specific distribution policy or
specific sales and redemption charge structure as shall be determined from time to time by the Board of directors for
each Sub-Fund, subject to the investment restrictions provided by law or determined by the Board of directors.

3613

L

U X E M B O U R G

The Board of directors may further, within the meaning of Article 181 of the 2010 Law, decide to create within each

Sub-Fund one or more Classes of Shares whose assets will be commonly invested pursuant to the specific investment
policy of the Sub-Fund concerned but may differ, inter alia, in respect of specific sales and redemption charge structure,
management charge structure, distribution policy, hedging policy or any other features as the Board of directors shall
from time to time determine in respect of each Sub-Fund.

In accordance with the above the Board may decide to issue within the same Class of Shares or Sub-Fund two categories

where one category is represented by capitalization Shares («Accumulation Shares») and the second category is repre-
sented by distribution Shares («Distribution Shares»). The Board may decide if and from what date Shares of any such
categories shall be offered for sale, those Shares to be issued on the terms and conditions as shall be decided by the
Board.

For the purpose of determining the capital of the Company, the net assets attributable to each Class/category of Shares

shall, if not expressed in Euro, be converted into Euro and the capital shall be the total of the net assets of all the Classes/
categories of Shares.

In these Articles, any reference to a Class of Shares might be construed as a reference to a Sub-Fund or a category of

Shares if the context so requires.

For each sub-fund, shares are only issued in registered form as further specified under the applicable sales documents

of the Fund.

Shares in registered form are dematerialised. No shares certificate will be issued.
The Fund may issue fractional shares (thousands). In case fractional registered shares are issued, a confirmation of

subscription shall be issued.

Shares must be fully paid-up and are issued with no par value. There is no restriction with regard to the number of

shares which may be issued.

The  inscription  of  the  shareholder’s  name  in  the  shareholders'  register  evidences  his  right  to  ownership  of  such

registered shares. The shareholders’ register is kept at the register office of the Fund.

Every registered shareholder must provide the Fund with an address to which all notices and announcements from

the Fund may be sent. Such address will be entered in the Register of Shareholders.

In the event that such shareholder does not provide with such address, the Fund may permit a notice to this effect to

be entered in the Register of Shareholders and the shareholder's address will be deemed to be at the registered office
of the Fund, or such other address as may be so entered by the Fund from time to time, until another address shall be
provided to the Fund by such shareholder. The shareholder may, at any time, change his address as entered in the Register
of Shareholders by means of a written notification to the Fund at its registered office, or at such other address as may
be set by the Fund from time to time.

Art. 7. Restriction on ownership. The Fund may restrict or prevent the ownership of Shares in the Fund by any person,

firm or corporate body, if in the opinion of the Fund such holding would present a violation of the laws of the Grand
Duchy or abroad, or if as a result thereof the Fund may become subject to taxation in countries other than the Grand
Duchy or may otherwise be detrimental to the Fund. For this purpose, the Fund may:

a) refuse the issuance of Shares and registration of the transfer of shares, if it appears that such issuance or such transfer

would or could result in the attribution of property of the share to a person not authorized to hold shares of the Fund;

b) request at any time that a person appearing in the Register of Shareholders, or any other person requesting the

registration of a share transfer, to furnish all information and certificates it deems necessary, including and not limited to
a sworn declaration in order to determine whether such shares are or shall effectively be owned by a person authorized
to hold shares of the Fund and

c) proceed in the compulsory repurchase of all the shares, if it appears that a person not authorized to hold shares in

the Fund, be it individually or jointly with other persons, is the owner of shares in the Fund, or proceed to the compulsory
repurchase of all or part of such shares, if it appears to the Fund that one or several persons are owners of a percentage
of shares in the Fund which would result in the Fund being subject to tax laws or other laws, of jurisdictions other than
those of Luxembourg. In such case, it will be processed as follows:

1.  The  Fund  shall  send  a  notice  (hereafter  named  "repurchase  notice")  to  the  shareholder  owning  the  shares  or

appearing in the Register of Shareholders as owner of the shares to repurchase; the repurchase notice shall specify the
securities to be repurchased, the repurchase price payable and the place where such price is to be paid. The repurchase
notice shall be mailed to the shareholder by registered letter addressed to his last known address or such address as
entered in the Register of Shareholders. The shareholder concerned shall be bound to present without delay to the Fund
the certificate(s), if any, representing the shares specified in the repurchase notice. Upon the closure of the offices of the
Fund on the day specified in the repurchase notice, the shareholder concerned shall cease to be the owner of the shares
specified in the repurchase notice; and if the relevant shares are in his name as a holder, such shares shall be barred in
the Register of Shareholders;

2. The price at which the shares specified in the repurchase notice are repurchased (the "repurchase price") shall be

equal to the net assets of the shares in the Fund, as determined on the day of the repurchase notice according to Article
22 of these Articles;

3614

L

U X E M B O U R G

3. Payment of the repurchase price shall be made in the valuation currency of the concerned Sub-Fund to the owner

of the Shares; the amount shall be deposited by the Fund with a bank in Luxembourg or elsewhere (as specified in the
repurchase notice), which will remit the amount to the shareholder concerned against delivery of the certificate(s), if any,
representing the Shares indicated in the repurchase notice. Immediately after the payment of the price under these
conditions, no person interested in the Shares mentioned in the repurchase notice is entitled to assert claims on such
shares nor exercise any action against the Fund or its assets, except the right of a shareholder appearing as the owner
of the Shares, to receive the amount deposited (without interest) at the bank in exchange for the restitution of the
certificate(s), if issued;

4. The exercise by the Fund of rights granted in this Article may in no case be challenged or invalidated on the grounds

that ownership of the Shares in the Fund is not sufficiently evidenced for a person by the Fund when sending the repurchase
notice, under the sole condition that the Fund

5. exercises its powers in good faith; and
d) the Fund may refuse at any general meeting the voting right of any person not authorized to hold shares in the Fund.
In particular, the Shares are not being offered in the United States, and may be so offered only pursuant to an exemption

from registration under the Securities Act of 1933, as amended (the “1933 Act”). The Shares have not been registered
with the Securities and Exchange Commission or any state securities commission nor has the Fund been registered under
the Investment Company Act of 1940, as amended (the “1940 Act”). No transfer or sale of the Shares shall be made
unless, among other things, such transfer or sale is exempt from the registration requirement of the 1933 Act and any
applicable state securities laws, or is made pursuant to an effective registration statement under the 1933 Act and such
securities laws and would not result in the Fund becoming subject to registration or regulation under the 1940 Act.

Art. 8. General Meetings. Any regularly constituted meeting of the Shareholders of the Fund shall represent the entire

body of Shareholders of the Fund. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the
operations of the Fund.

Art. 9. Annual General Meeting. The annual general meeting of Shareholders shall be held, in accordance with Lu-

xembourg law, in Luxembourg at the registered office of the Fund, or at such other place in Luxembourg as may be
specified in the notice of meeting, on the 29 

th

 of the month of April each year at 2:00 p.m. (Luxembourg time) or, if any

such  day  is  not  a  Bank  Business  Day,  on  the  next  following  Bank  Business  Day.  The  first  annual  general  meeting  of
Shareholders will be held on 29 

th

 April, 2016. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final

judgment of the Board of directors, exceptional circumstances so require.

Other meetings of Shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of

meeting.

Art. 10. Holding of the Meeting. The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the

meetings of Shareholders of the Fund, unless otherwise provided herein.

Each share of whatever Class, regardless of the net asset value per share within its Class, is entitled to one vote. A

shareholder may act at any meeting of Shareholders by appointing another person as his proxy in writing or telegram,
telex or facsimile. Such proxy shall be valid for any reconvened meeting unless it is specifically revoked.

Except as otherwise required by law or as otherwise provided herein, resolutions at a meeting of Shareholders duly

convened will be passed by a simple majority of those present and voting.

The Board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by Shareholders for them to take part

in any meeting of Shareholders.

Art. 11. Convening of General Meetings. Shareholders will meet upon call by the Board of directors, pursuant to notice

setting forth the agenda sent by mail at least eight days prior to the meeting to each shareholder at the shareholder's
address in the Register of Shareholders.

Notice shall be published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations of Luxembourg and in a Luxembourg

newspaper to the extent required by Luxembourg law, and in such other newspapers as the Board of directors may
decide.

By derogation to the Law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, the Fund is not required to send

the annual accounts, as well as the report of the approved statutory auditor and the management report to the registered
shareholders at the same time as the convening notice to the annual general meeting. The convening notice shall indicate
the  place  and  practical  arrangements  for  providing  these  documents  to  the  shareholders  and  shall  specify  that  each
shareholder  may  request  that  the  annual  accounts,  as  well  as  the  report  of  the  approved  statutory  auditor  and  the
management report are sent to him.

The convening notices to general meetings of shareholders may provide that the quorum and the majority at the

general meeting shall be determined according to the shares issued and outstanding at midnight (Luxembourg time) on
the fifth day prior to the general meeting (referred to as “Record Date”). The rights of a shareholder to attend a general
meeting and to exercise a voting right attaching to his shares are determined in accordance with the shares held by this
shareholder at the Record Date.

3615

L

U X E M B O U R G

Art. 12. Administration of the Fund. The Fund shall be managed by a Board of directors composed of not less than

three (3) members; who need not be Shareholders of the Fund.

The directors shall be elected by the Shareholders at their annual general meeting for a period ending at the next

annual general meeting and until their successors are elected and qualify, provided, however, that a director may be
removed with or without cause and/or replaced at any time by resolution adopted by the Shareholders.

In the event of a vacancy in the office of director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors

may meet and may elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next meeting of Shareholders.

Art. 13. Board Meeting. The Board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration

and disposition in the Fund’s interest, and more specifically to appoint a Luxembourg Management Company in accordance
with Chapter 15 of the 2010 Law.

The Board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its members

one or more vice-chairmen.

It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the

meetings of the Board of directors and of the Shareholders. The Board of directors shall meet upon call by the chairman,
or two directors, at the place indicated in the notice of meeting.

The chairman shall preside at all meetings of Shareholders and the Board of directors, but in his absence the Share-

holders or the Board of directors may appoint another director (and, in respect of Shareholders' meetings, any other
person) as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting. The chairman shall have casting
vote.

The Board of directors from time to time may appoint the officers of the Fund, including a general manager, a secretary,

and any deputy general manager, deputy secretaries or other officers considered necessary for the operation and mana-
gement of the Fund. Any such appointment may be revoked at any time by the Board of directors. Officers need not be
directors or Shareholders of the Fund. The officers appointed, unless otherwise stipulated in these Articles, shall have
the powers and duties given to them by the Board of directors.

Written notice of any meeting of the Board of directors shall be given to all directors at least twenty-four hours in

advance  of  the  hour  set  for  such  meeting,  except  in  circumstances  of  emergency,  in  which  case  the  nature  of  such
circumstances shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by
telegram, telex, facsimile or e-mail of each director. Separate notice shall not be required for individual meetings held at
times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the Board of directors.

Any director may act at any meeting of the Board of directors by appointing in writing or by e-mail, telegram, telex

or facsimile another director as his proxy.

The directors may only act at duly convened meetings of the Board of directors. Directors may not bind the Fund by

their individual acts, except as specifically permitted by resolution of the Board of directors.

The Board of directors can deliberate or act validly only if at least its half members are present or represented at a

meeting of the Board of directors. Resolutions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or
represented at such meeting. The Board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs
of the Fund and its powers to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose, to officers of the Fund
or to any other contracting parties.

A director may also participate at any meeting of the Board of directors by conference call or videoconference or any

other means of telecommunication allowing to identify such director. Such means must allow the director to effectively
act at such meeting of the Board of directors, and is subject to confirmation in writing to the vote.

The directors, acting unanimously by a circular resolution, may express their consent on one or several separate

instruments in writing or by telex, e-mail, telegram or facsimile transmission confirmed in writing which shall together
constitute appropriate minutes evidencing such decision.

Art. 14. Minutes. The minutes of any meeting of the Board of directors shall be signed by the chairman or, in his

absence, by the chairman pro tempore who presided at such meeting.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the

chairman, or by the secretary, or by two directors.

Art. 15. Powers of the Board of directors. The Board of directors shall, based upon the principle of spreading of risks,

have power to determine the corporate and investment policy and the course of conduct of the management and business
affairs of the Fund.

The Board of directors shall also determine any restrictions which shall from time to time be applicable to the invest-

ments of the Fund in accordance with Part I of the 2010 Law.

The Board of directors may decide that investment of the Fund be made (i) in transferable securities and money market

instruments admitted to or dealt in on a regulated market as defined by the 2010 Law, (ii) in transferable securities and
money market instruments dealt in on another market in a member state of the European Union which is regulated,
operated regularly and is recognised and open to the public, (iii) in transferable securities and money market instruments
admitted to official listing in Eastern and Western Europe, Africa, the American continents, Asia and Oceania or dealt in

3616

L

U X E M B O U R G

on another market in the countries referred to above, provided that such market is regulated, operates regularly and is
recognized and open to the public, (iv) in recently issued transferable securities and money market instruments provided
that the terms of the issue include an undertaking that an application will be made for admission to official listing on any
of the stock exchanges or other regulated markets referred to above and provided that such listing is secured within one
year of the issue, as well as (v) in any other securities, instruments or other assets within the restrictions as shall be set
forth by the Board of directors in compliance with applicable laws and regulations and disclosed in the sales documents
of the Fund.

The Board of directors of the Fund may decide to invest under the principle of risk-spreading up to 100 % of the total

net assets of each Sub-Fund of the Fund in different transferable securities and money market instruments issued or
guaranteed by any member state of the European Union, its local authorities, a non-member state of the European Union,
as  acceptable  by  the  Luxembourg  supervisory  authority  and  disclosed  in  the  sales  documents  of  the  Fund  or  public
international bodies of which one or more of member states of the European Union are members, provided that in the
case where the Fund decides to make use of this provision the relevant Sub-Fund must hold securities from at least six
different issues and securities from any one issue may not account for more than 30 % of such Sub-Fund’s total net assets.

The Board of directors may decide that investments of the Fund be made in financial derivative instruments, including

equivalent cash settled instruments, dealt in on a regulated market as referred to in the 2010 Law and/or financial derivative
instruments dealt in over-the-counter provided that, among others, the underlying consists of instruments covered by
Article 41 (1) of the 2010 Law, financial indices, interest rates, foreign exchange rates or currencies, in which the Fund
may invest according to its investment objectives as disclosed in the sales documents of the Fund.

The Board of directors may decide that investments of the Fund be made so as to replicate a certain stock or bond

index provided that the relevant index is recognised by the Luxembourg supervisory authority as having a sufficiently
diversified composition, is an adequate benchmark and is clearly disclosed in the sales documents of the Fund.

The Board of directors will not invest more than 10% of the total net assets of a Sub-Fund in units of undertakings for

collective investments as defined in article 41 (1) e) of the 2010 Law unless otherwise provided specifically for a Sub-Fund
in the sales document of the Fund. For the purpose of the application of this investment limit, each compartment of a
UCI with multiple compartments within the meaning of Article 181 of this 2010 Law is to be considered as a separate
issuer provided that the principle of segregation of the obligations of the various compartments vis-à-vis third parties is
ensured.

Investments made in units of UCIs other than UCITS may not in aggregate exceed 30% of the total net assets of the

Company.

Art. 16. Conflict of Interest. No contract or other transaction between the Fund and any other corporation or firm

shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Fund is interested in,
or is a director, associate, officer or employee of such other corporation or firm. Any director or officer of the Fund
who serves as a director, officer or employee of any corporation or firm with which the Fund shall contract or otherwise
engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other corporation or firm be prevented from consi-
dering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

In the event that any director or officer of the Fund may have an interest in any transaction of the Fund submitted for

approval to the Board of directors and which conflicts with the interests of the Fund, such Director or officer shall make
known to the Board of directors such conflicts of interest and shall not consider or vote on any such transaction, and
such transaction, and such Director's or officer's interest therein, shall be reported to the next succeeding meeting of
Shareholders.

Such conflicts of interests as referred to in this Article sixteen, shall not include any relationship with or interest in

any matter, position or transaction involving any affiliated or associated company of any external investment manager
appointed by the Fund, or such other person, corporation or entity as may from time to time be determined by the Board
of directors on its discretion.

Art. 17. Indemnification. The Fund may indemnify any director or officer, and his heirs, executors and administrators,

against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made
a party by reason of his being or having been a director or officer of the Fund or, at its request, of any other corporation
of which the Fund is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to
matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or wilful
misconduct. In the event of a settlement, any indemnity shall be provided only in connection with such matters covered
by the settlement as to which the Fund is advised by its counsel that the person to be indemnified did not commit such
a breach of duty. The foregoing right of indemnity shall not exclude other rights to which he may be entitled.

As remuneration for their activities, the general meeting may allocate to the directors a fixed annual sum as directors'

fees, the amount of which shall be considered as part of the general operating expenses of the Fund and which may be
apportioned between the directors at their discretion.

Moreover, the directors may be reimbursed for expenses incurred for the Fund to the extent that they are deemed

reasonable.

3617

L

U X E M B O U R G

Art. 18. Commitment of the Fund towards third party. The Fund will be bound by the joint signature of any two

directors, by the individual signature of any duly authorized officer of the Fund or by the individual signature of any other
person to whom the Board of directors has conferred special powers. The Board may also delegate the daily management
and affairs of the Fund to one of its members.

Art. 19. Auditor. Business of the Fund as well as its financial situation, including in particular the keeping of the accounts,

shall be supervised by an independent auditor who shall carry out his duties as required by the 2010 Law.

The independent auditor shall be appointed by the general meeting of the shareholders. The independent auditor in

office may be revoked in accordance with the laws in force.

Art. 20. Issue, Conversion, Redemption and Transfer of Shares. Initial offer details for new Sub-Funds are disclosed in

the applicable sales documents of the Fund.

Unless otherwise provided for a Sub-Fund in the applicable sales documents of the Fund, subscriptions for shares in

each Sub-Fund can be made on any Bank Business Day. Applications for subscriptions will normally be satisfied, if accepted,
on a Valuation Date, provided that the application is received by 4.00 p.m. (Luxembourg time) the Bank Business Day
preceding such Valuation Date.

Applications notified after this deadline will be satisfied on the next following Valuation Date.
The subscription price is payable in the currency of the relevant share class within three Bank Business Days following

the applicable Valuation Date.

Applications for subscriptions must be sent in writing, fax or swift to the Administrative Agent or with any other

appointed agent (if sent by fax or by electronic means to be followed promptly by the original by post only for the first
subscription and with the mention “already faxed”).

Applications for subscription may, at the subscriber's choice, pertain to a number of shares to be subscribed or to an

amount to be invested in the Fund. Only in this latter case, fractional shares might be issued.

The rights attached to the shares are those provided for in the Luxembourg law of 10 

th

 August 1915 on commercial

companies, as amended, unless superseded by the 2010 Law.

All shares of the Fund have an equal voting right, whatever their value (except that portion of a share that is a fractional

share). The shares of the Fund have an equal right to the liquidation proceeds of the Fund.

The countries where the Fund is distributed may decide to apply minimum subscription amounts as described in the

local documents in force.

The minimal initial subscription in any Sub-Fund is specified in the applicable sales documents of the Fund. The holding

value in each Sub-Fund may only fall below such minimum as a result of a decrease of the net asset value per share of the
Sub-Fund concerned.

Shares shall be allotted at the net asset value per share determined as of the Valuation Date following the Bank Business

Day on which the application has been accepted.

In certain countries, investors may be charged with additional amounts in connection with the duties and services of

local paying agents, correspondent banks or similar entities.

Shares may be subscribed against contributions in kind considered acceptable by the Board of Directors on the basis

of the investment policy of the relevant Sub-Fund and will be valued in an auditor's report as required by Luxembourg
law. The relevant fees will be paid by the subscriber.

The Fund reserves the right to:
- accept or refuse any application in whole or in part and for any reason;
- repurchase, at any time, shares held by persons not authorised to buy or own the Fund's shares.
The Fund may also limit the distribution of shares of a given Sub-Fund to specific countries.
The Fund has delegated to the Management Company the administration and marketing services in respect of all the

sub-funds. Pursuant to such delegation, the Management Company or its delegates will monitor the prevention of anti-
money laundering measures. Measures aimed at the prevention of money laundering may require an applicant for shares
to certify its identity to the Management Company or its delegates. Depending on the circumstances of each application,
verification may not be required where the applicant makes the payment from an account held in the applicant’s name at
a recognised financial institution, or the application is made through a recognised intermediary. These exceptions will
only apply if the financial institution or intermediary referred to above is established within a country recognised by
Luxembourg as having equivalent anti-money laundering regulations.

Shareholders are informed that their personal data or information given in the subscription documents or otherwise

in connection with an application to subscribe for shares, as well as details of their shareholding, will be stored in digital
form and processed in compliance with the provisions of the Luxembourg law of 2 

nd

 August 2002 on data protection.

In particular, such process of personal data or information implies that subscribing the Fund, Shareholders consent that
their personal data or any information relating to them be disclosed (i) to any entity of the promoter's group and any
affiliate, or (ii) to any authority in any country when required by law or regulation.

3618

L

U X E M B O U R G

The Fund shall normally issue confirmations of shareholding to the holder of shares. The inscription of the shareholder’s

name in the register of Shareholders evidences his right of ownership of such registered shares.

Confirmation  of  completed  subscriptions  together  with  share  certificates,  if  applicable,  may  be  sent  by  fax,  swift,

dedicated interface file or by mail at the risk of the investor, to the address indicated in the subscription form within
seven Bank Business Days following the issue of the shares.

Issue of shares of a given Sub-Fund shall be suspended whenever the determination of the net asset value per share

of such Sub-Fund is suspended by the Fund as provided into the applicable sales documents of the Fund.

Subject to any suspension of the determination of the net asset values concerned and to compliance with any eligibility

conditions, Shareholders have the right to convert all or part of the shares they hold in any Sub-Fund/Class of shares into
shares of another existing Sub-Fund/Class of shares by making a request in writing, by fax to the Administrative Agent
indicating the number and the reference name of the shares to be converted.

The conversion request must be received by 4.00 p.m. (Luxembourg time) the Bank Business Day preceding the

applicable Valuation Date and must be accompanied by a duly filled out transfer form, or by any document vouching for
the transfer.

Requests received after this deadline will be satisfied on the next following Valuation Date.
The number of shares issued upon conversion will be based upon the respective net asset values of the shares of the

two Sub-Funds concerned on the common Valuation Date following the Bank Business Day on which the conversion
request is accepted.

If the net asset values concerned are expressed in different currencies, the conversion will be calculated by using the

exchange rate applicable on the relevant Valuation Date on which the conversion is to be effected.

Under the responsibility of the Board of Directors and with the approval of the Shareholders concerned, conversions

may be effected in kind by transfer of a representative selection of the original Sub-Fund’s/Class of shares' holding in
securities and cash pro rata to the number of shares converted, to the receiving Sub-Fund/Class of shares having a
compatible investment policy as certified by the auditor of the Fund.

Any expenses incurred in the transfers shall be borne by the Shareholders concerned.
After the conversion, the Fund shall inform the shareholders of the number of new shares obtained at conversion as

well as their price.

In addition, if, as a result of a conversion, the value of a Shareholder's remaining holding in the original Sub-Fund/Class

of shares would become less than the minimum holding referred to for each Sub-Fund/Class of shares in the applicable
sales documents of the Fund, the relevant Shareholder will be deemed to have requested the conversion of all of his
shares.

Any Shareholder may present to the Administrative Agent his request for redemption by number of shares or by

amount to be redeemed. The redemption can be done in part or whole on any Valuation Date.

Redemption requests received until 4.00 p.m. (Luxembourg time) the Bank Business Day preceding a Valuation Date

(the “Cut-off time”) will be executed at the net asset value per share determined as of that Valuation Date. Redemption
requests received after the Cut-off time will be executed on the following Valuation Date.

Redemption payments will be made in the currency of the relevant shares class at the latest on the third Bank Business

Day following the applicable Valuation Date.

Under the responsibility of the Board of Directors and with the approval of the Shareholders concerned redemptions

may be effected in kind. Shareholders are free to refuse the redemption in kind and to insist upon cash redemption
payment in the reference currency of the relevant shares class. Where Shareholders agree to accept redemption in kind
they will, to the extent possible, receive a representative selection of the Sub-Fund's holding in securities and cash pro
rata to the number of shares redeemed. The value of the redemption in kind will be certified by an auditor's certificate
drawn up in accordance with the requirements of Luxembourg law. Any expenses incurred for redemptions in kind shall
be borne by the Shareholders concerned.

If, as a result of a redemption, the value of a Shareholder's holding in a Sub-Fund would become less than the minimum

holding referred to for each Class of shares in the applicable sales documents of the Fund, the relevant Shareholder will
be deemed (if so decided from time to time by the Board of Directors) to have requested redemption of all of his shares.
Also, the Board of Directors may, at any time, decide to compulsorily redeem all shares from Shareholders whose holding
in a Sub-Fund is less than the minimum holding referred to above. In case of such compulsory redemption, the Shareholder
concerned will receive a one month prior notice so as to be able to increase his holding above the minimum holding at
the applicable net asset value.

Where redemption requests received for one Sub-Fund on any Valuation Date exceed 10% of the net assets thereof,

the Board of Directors may delay the execution, or may only partially execute such redemption requests. Any shares
which, by virtue of this limitation, are not redeemed as at any particular Valuation Date shall be carried forward for
realisation on the next following applicable Valuation Date in priority to subsequent requests.

In normal circumstances the Board of Directors will maintain adequate level of liquid assets in order to meet re-

demption requests.

3619

L

U X E M B O U R G

Redemption of shares of a given Sub-Fund shall be suspended whenever the determination of the net asset value per

share of such Sub-Fund is suspended by the Fund as provided into the applicable documents of the Fund.

A Shareholder may not withdraw his request for redemption of shares of any one Sub-Fund except in the event of a

suspension of the determination of the net asset value of the shares of such Sub-Fund and, in such event, a withdrawal
will be effective only if written notification is received by the Administrative Agent before the termination of the period
of suspension. If the request is not withdrawn, the Fund shall proceed to redemption on the first applicable Valuation
Date following the end of the suspension of the determination of the net asset value of the shares of the relevant Sub-
Fund.

The redemption price for shares of the Fund may be higher or lower than the purchase price paid by the shareholder

at the time of subscription due to the appreciation or depreciation of the net assets.

A Shareholder may request the transfer of part or all of his Shares to another person. The transfer may only be

processed provided the Fund is satisfied that the transferor and the transferee fulfill all the requirements applicable to
redemption and subscription of Shares.

The transfer of Shares may normally be effected by delivery to the relevant Registrar and Transfer Agent of an ins-

trument of transfer in appropriate form. On the receipt of the transfer request, and after reviewing the endorsement(s),
signature(s) may be required to be certified by an approved bank, stock broker or public notary.

The right to transfer Shares is subject to the minimum investment and holding requirements as further disclosed for

each Sub-Fund in the applicable sales documents of the Fund.

Shareholders are advised to contact the relevant Registrar and Transfer Agent prior to requesting a transfer to ensure

that they have the correct documentation for the transaction.

Art. 21. Suspension of the Net Asset Value calculation and of the issue, conversion and redemption of shares. For the

purpose of determination of the issue, redemption and conversion prices, the Net Asset Value of Shares in the Fund shall
be determined as to the Shares of each Class of Shares by the Fund from time to time, but in no instance less than twice
monthly, as the Board of directors by regulation may direct (every such day or time for determination of Net Asset Value
being referred to herein as a "Valuation Date"), provided that in any case where any Valuation Date would fall on a day
observed as a holiday by banks in Luxembourg or in any other place to be determined by the Board of directors, such
Valuation Date shall then be the next bank business day following such holiday.

The Fund may suspend the determination of the Net Asset Value of Shares of any particular Class and the issue and

redemption of its Shares from its Shareholders as well as conversion from and to Shares of each Class during:

a) any period when any of the principal stock exchanges or organized markets on which any substantial portion of the

investments of the Fund attributable to such Sub-Fund from time to time are quoted or dealt in is closed otherwise than
for ordinary holidays, or during which dealings therein are restricted or suspended; or

b) the existence of any state of affairs which constitutes an emergency as a result of which disposals or valuation of

assets owned by the Fund attributable to such Sub-Fund would be impracticable; or

c) any period when the Fund is unable to repatriate funds for the purpose of making payments on the redemption of

the Shares of such Sub-Fund or during which any transfer of funds involved in the realisation or acquisition of investments
or payments due on redemption of Shares cannot in the opinion of the directors be effected at normal rates of exchange;
or

d) as soon as the decision to liquidate one or more Sub-Fund/Classes of Shares is taken or in the case of the Fund's

dissolution; or

e) any period when any Sub-Fund of the Fund is a feeder of a master UCITS which is itself entitled to suspend the Net

Asset Value, the redemption or subscription of its shares, whether at its own initiative or at the request of its competent
authorities; the determination of the Net Asset Value of shares and the issue, redemption and conversion of shares shall
be suspended within the same period of time as the master UCITS; or

f) if, in exceptional circumstances, the Board of Directors determines that suspension of the determination of Net

Asset Value is in the best interest of Shareholders (or shareholders in that sub-fund as appropriate).

Any such suspension shall be publicized, if appropriate, by the Fund and shall be notified to Shareholders requesting

purchase of their Shares by the Fund at the time of the filing of the written request for such purchase as specified in
Article twenty hereof.

Such suspension as to any Sub-Fund/Class of Shares shall have no effect on the calculation of the Net Asset Value, the

issue, redemption and conversion of the Shares of any other Sub-Fund/Class of Shares.

Any redemption/conversion request made or in abeyance during such a suspension period may be withdrawn by

written notice to be received by the Fund before the end of such suspension period. Should such withdrawal not be
effected, the shares in question shall be redeemed/converted on the first Valuation Date following the termination of the
suspension period. In the event of such period being extended, notice may be published in newspapers in the countries
where the Fund's shares are publicly sold. Investors who have requested the issue, redemption or conversion of shares
shall be informed of such suspension when such request is made.

3620

L

U X E M B O U R G

Art. 22. Net Asset Value. The Net Asset Value of Shares of each Sub-Fund/Class of Shares in the Fund shall be expressed

as a per share figure in the currency of the relevant Sub-Fund/Class of Shares and shall be determined in respect of any
Valuation Date by dividing the net assets of the Fund corresponding to each Class of Shares (being the assets of the Fund
corresponding to such Class, less its liabilities attributable to such Class at the close of business on such date) by the
number of Shares of the relevant Class then outstanding and by possibly rounding the resulting sum up or down to the
nearest unit of currency, in the following manner:

A. The assets of the Fund shall be deemed to include:
a) all cash in hand or receivable or on deposit, including any interest accrued thereon;
b) all bills and demand notes and accounts receivable (including proceeds of securities sold but not delivered);
c) all bonds, time notes, Shares, units/Shares in undertakings for collective investment, stock, debenture stocks, sub-

scription rights, warrants, options and other investments and securities owned or contracted for by the Fund;

d) all stock, stock dividends, cash dividends and cash distributions receivable by the Fund (provided that the Fund may

make adjustments with regard to fluctuations in the market value of securities caused by trading ex-dividends, ex-rights,
or by similar practices);

e) all interest accrued on any interest-bearing securities owned by the Fund except to the extent that the same is

included or reflected in the principal amount of such security;

f) the preliminary expenses of the Fund insofar as the same have not been written off, and
g) all other assets of every kind and nature, including prepaid expenses.
The value of such assets shall be determined as follows:
(1) The value of any cash on hand or on deposit, bills and demand notes and accounts receivable, prepaid expenses,

cash dividends and interest declared or accrued as aforesaid and not yet received shall be deemed to be the full amount
thereof, unless in any case the same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof shall be
arrived at after making such discount as the Fund may consider appropriate in such case to reflect the true value thereof.

(2) The value of securities and/or financial derivative instruments which are quoted or dealt in on any stock exchange

shall be based on the last available prices of the Valuation Date and, if appropriate, on the average price on the stock
exchange  which  is  normally  the  principal  market  of  such  securities  and/or  financial  derivative  instruments,  and  each
security and/or financial derivative instrument traded on any other regulated market shall be valued in a manner as similar
as possible to that provided for quoted securities and/or financial derivative instruments;

(3) for non-quoted securities or securities not traded or dealt in on any stock exchange or other regulated market,

as well as quoted or non-quoted securities on such other market for which no valuation price is available, or securities
for which the quoted prices are not representative of the fair market value, the value thereof shall be determined prudently
and in good faith on the basis of foreseeable sales prices;

(4) Shares or units in open-ended investment funds shall be valued at their last available calculated net asset value;
(5) liquid assets and money market instruments may be valued at nominal value plus any accrued interest or on an

amortised cost basis as determined by the Board of directors. All other assets, where practice allows, may be valued in
the same manner.

(6) The financial derivative instruments which are not listed on any official stock exchange or traded on any other

organised market will be valued in accordance with market practice.

(7) swaps are valued at their fair value based on the underlying securities.
In the event that the above mentioned calculation methods are inappropriate or misleading, the Board of directors

may adjust the value of any investment or permit some other method of valuation to be used for the assets of the Fund
if it considers that the circumstances justify that such adjustment or other method of valuation should be adopted to
reflect more fairly the value of such investments.

In circumstances where the interests of the Fund or its Shareholders so justify (avoidance of market timing practices,

for example), the Board of directors may take any appropriate measures, such as applying a fair value pricing methodology
to adjust the value of the Fund's assets, as further described in the sales documents of the Fund.

B. The liabilities of the Fund shall be deemed to include:
a) all loans, bills and accounts payable;
b) all accrued or payable administrative expenses (including investment advisory fee, custodian fee and corporate

agents' fees);

c) all known liabilities, present and future, including all matured contractual obligations for payments of money or

property, including the amount of any unpaid dividends declared by the Fund where the Valuation Date falls on the record
date for determination of the person entitled thereto or is subsequent thereto;

d) an appropriate provision for future taxes based on capital and income to the Valuation Date, as determined from

time to time by the Fund, and other reserves if any authorized and approved by the Board of directors and

e) all other liabilities of the Fund of whatsoever kind and nature except liabilities represented by Shares in the Fund.

In determining the amount of such liabilities the Fund shall take into account all expenses payable by the Fund comprising
formation expenses, the remuneration and expenses of its directors and officers, including their insurance cover, fees

3621

L

U X E M B O U R G

payable to its investment advisers or investment managers, fees and expenses of service providers and officers, accoun-
tants, custodian and correspondents, domiciliary, registrar and transfer agents, any paying agent and permanent repre-
sentatives in places of registration, any other agent employed by the Fund, fees for legal or auditing services, promotional,
printing, reporting and publishing expenses, including the cost of advertising or preparing and printing of the sales docu-
ments,  explanatory  memoranda  or  registration  statements,  taxes  or  governmental  charges,  and  all  other  operating
expenses, including the cost of buying and selling assets, interest, bank charges and brokerage, postage, telephone and
telex. The Fund may calculate administrative and other expenses of a regular or recurring nature and on estimated figure
for yearly or other periods in advance, and may accrue the same in equal proportions over any such period.

C. There may be established a pool of assets for each Class of Shares in the following manner:
a) the proceeds from the issue of each Class of Shares may be applied in the books of the Fund to the pool of assets

established for that Class of hares, and the assets and liabilities and income and expenditure attributable thereto shall be
applied to such pool subject to the provisions of this article;

b) where any asset is derived from another asset, such derivative asset may be applied in the books of the Fund to the

same pool as the assets from which it was derived and on each revaluation of an asset, the increase or diminution in value
shall be applied to the relevant pool;

c) where the Fund incurs a liability which relates to any asset of a particular pool or to any action taken in connection

with an asset of a particular pool, such liability shall be allocated to the relevant pool,

d) in the case where any asset or liability of the Fund cannot be considered as being attributable to a particular pool,

such asset or liability shall be equally divided between all the pools or, as insofar as justified by the amounts, shall be
allocated to the pools pro rata to the net asset values of the relevant Class of Shares;

e) upon the record date for determination of the person entitled to any dividend declared on any Class of Shares, the

Net Asset Value of such Class of Shares shall be reduced by the amount of such dividends.

If there have been created, as more fully described in Article 6 hereof, within the same Sub-Fund two or several Classes,

the allocation rules set out above shall apply, mutatis mutandis, to such Classes.

D. For the purposes of this Article:
a) Shares of the Fund to be redeemed under Article twenty hereof shall be treated as existing and taken into account

until immediately after the close of business on the Valuation Date referred to in this Article, and from such time and
until paid the price therefore shall be deemed to be a liability of the Fund;

b) all investments, cash balances and other assets of the Fund not expressed in the currency in which the Net Asset

Value of any Class is denominated, shall be valued after taking into account the market rate or rates of exchange in force
at the date and time for determination of the Net Asset Value of Shares and

c) Shares to be issued by the Fund pursuant to subscription applications received shall be treated as being in issue as

from the close of business on the Valuation Date referred to in this Article and such price, until received by the Fund,
shall be deemed to be a debt due to the Fund.

d) effect shall be given on any Valuation Date to any purchases or sales of securities contracted for by the Fund on

such Valuation Date, to the extent practicable;

Art. 23. Accounting year and currency of the Fund. The accounting year of the Fund shall begin on the 1 

st

 January of

a year and shall terminate on the 31 

st

 December with the exception of the first accounting year which shall begin on the

date of incorporation of the Fund and shall end on the 31 

st

 December 2015.

The accounts of the Fund shall be expressed in Euro. When there shall be different Sub-Funds/Classes as provided for

in Article 6 hereof, and if the accounts within such Sub-Funds/Classes are expressed in different currencies, such accounts
shall be translated into Euro and added together for the purpose of the determination of the accounts of the Fund.

Art. 24. Profit Balance. The appropriation of the annual results and any other distributions shall be determined by the

annual general meeting upon proposal by the Board of directors.

Any resolution of a general meeting of Shareholders deciding on whether or not dividends are declared to the Shares

of any Class or whether any other distributions are made in respect of each Class of Shares shall, in addition, be subject
to a prior vote, at the majority set forth above, of the Shareholders of such Class.

The Board of directors may approve the payment of interim dividends for the past or the current financial year subject

to such further conditions as set forth by law

No distribution may be made if as a result thereof the capital of the Fund became less than the minimum prescribed

by law.

The dividends declared will be paid in such currencies at such places and times as shall be determined by the Board

of directors.

Dividends may further, in respect of any Class of Shares, include an allocation from an equalization account which may

be maintained in respect of any such Class and which, in such event, will, in respect of such Class be credited upon issue
of Shares and debited upon redemption of Shares, in an amount calculated by reference to the accrued income attributable
to such Shares.

3622

L

U X E M B O U R G

Upon the creation of a Class of Shares, the Board of directors may decide that all Shares of such Class shall be

Accumulation Shares and that, accordingly, no dividends will be distributed in respect of such Shares. The Board of
Directors may also decide that there shall be issued, within the same Class of shares, two Categories where one Category
is represented by capitalization shares and the second Category is represented by distribution shares. No dividends shall
be declared in respect of capitalization Shares issued as aforesaid.

Art. 25. Custodian. The Fund shall enter into a custodian agreement with a bank which shall satisfy the requirements

of the 2010 Law (the "Custodian"). All securities and cash of the Fund are to be held by or to the order of the Custodian
who shall assume towards the Fund and its Shareholders the responsibilities prescribed by law.

In the event of the Custodian desiring to retire, the directors shall use their best endeavours to find a corporation to

act as custodian and upon doing so the directors shall appoint such corporation to be custodian in place of the retiring
Custodian. The Board of directors may terminate the appointment of the Custodian, but shall not remove the Custodian
unless and until a successor custodian shall have been appointed in accordance with this provision to act in the place
thereof.

Art. 26. Dissolution, Liquidation, Merger. The Board of Directors may at any moment and for any reason whatsoever

propose the dissolution and liquidation of the Fund to an extraordinary general meeting. The issue of new Shares and
the repurchase by the Fund of Shares from holders as presented for repurchase shall cease on the day of publication of
the convening notice for the general meeting in which the dissolution and the liquidation of the Fund are proposed.

In the event of the winding up of the Fund, liquidation shall be carried out by one or several liquidators who may be

individuals or legal entities and who shall have been appointed by the general meeting of Shareholders, which shall de-
termine their powers and their compensation.

The net liquidation proceeds in each Sub-Fund shall be distributed to the holders of Shares proportionally with respect

to  the  number  of  Shares  they  hold  in  the  relevant  Sub-Fund.  Amounts  not  claimed  by  Shareholders  at  the  close  of
liquidation shall be deposited with the "Caisse de Consignations" in Luxembourg within nine months following the decision
of liquidation.

A Sub-Fund, respectively a Class, may be dissolved by compulsory redemption of Shares of the Sub-Fund/Class con-

cerned, upon:

a) a decision of the Board of directors if the net assets of the Class concerned have decreased below Euro 5 million

or the equivalent in another currency during a certain period of time as disclosed in the applicable sales documents of
the Fund, or if the net assets of the Sub-Fund or Class concerned have decreased below such an amount considered by
the Board of Directors as the minimum level under which such Sub-Fund or Class may no longer operates in an econo-
mically efficient way, or if a change in the economic or political situation relating to the Sub-Fund or Class would justify
the liquidation of such Sub-Fund or Class, or if it is required by the interests of the Shareholders concerned, or

b) the decision of a meeting of holders of Shares of the relevant Sub-Fund/Class. There shall be no quorum requirement

and decisions may be taken by a simple majority of the Shares of the Class concerned.

In such event the Shareholders concerned will be advised and the net asset value of the Shares of the relevant Sub-

Fund/Class shall be paid on the date of the compulsory redemption. The relevant meeting may also decide that assets
attributable to the Class concerned will be distributed on a prorata basis to the holders of Shares of the relevant Sub-
Fund/Class which have expressed the wish to receive such assets in kind.

A meeting of holders of Shares of a Sub-Fund/Class may decide to amalgamate such Sub-Fund/Class with another

existing Sub-Fund/Class in the Fund or to contribute the assets (and liabilities) of such Sub-Fund/Class to another un-
dertaking for collective investment against issue of Shares of such undertaking for collective investments to be distributed
to the holders of Shares of the Sub-Fund/Class considered. If such amalgamation or contribution is required by the
interests of the Shareholders concerned or if the net assets of the Sub-Fund/Class have decreased below Euro 5 million
or the equivalent in another currency during a certain period of time as disclosed in the applicable sales documents of
the Fund, it may be decided by the Board of directors.

However, for any merger where the merging fund would cease to exist, the merger must be decided by a meeting of

shareholders of the merging fund deciding in accordance with the quorum and majority requirements provided by law.

Should the Fund cease to exist following a merger, the effective date of the merger must be recorded by notarial deed.
Insofar as a merger requires the approval of shareholders pursuant to the provisions above, only the approval of the

shareholders of the sub-fund concerned shall be required.

Any merger is subject to prior authorisation by the CSSF which shall be provided with specific information as described

in Article 67 of the 2010 Law, and, in particular, with the common draft terms of the proposed merger duly approved by
the merging fund and the receiving fund.

The common draft terms of the proposed merger shall set out particulars precisely listed in Article 69 of the 2010

Law including but not limited to:

a) an identification of the type of merger and of the funds involved,
b) the background to and the rationale for the proposed merger,
c) the expected impact of the proposed merger on the shareholders of both the merging and the receiving fund,

3623

L

U X E M B O U R G

d) the criteria adopted for valuation of the assets and, where applicable, the liabilities on the date for calculating the

exchange ratio,

e) the calculation method of the exchange ratio,
f) the planned effective date of the merger,
g) the rules applicable to the transfer of assets and the exchange of shares, respectively, and
h) as the case may be, the Instruments of Incorporation of the newly constituted receiving fund.
In accordance with Article 70 of the 2010 Law, the depositaries of the merging and the receiving funds, insofar as they

are established in Luxembourg, must verify the conformity of the particulars with the requirements of the 2010 Law and
the Instruments of Incorporation of their respective fund.

In accordance with Article 71 of the 2010 Law, the merging fund established in Luxembourg shall entrust either an

approved statutory auditor or, as the case may be, and independent auditor.

A copy of the reports of the approved statutory auditor or, as the case may be, the independent auditor shall be made

available on request and free of charge to the shareholders of both the merging and the receiving fund and to their
authoritive competent authorities.

Shareholders of the merging and the receiving fund shall be provided with appropriate and accurate information on

the proposed merger so as to be able to make an informed judgment of the impact of the merger on their investment.

The decision shall be published upon the initiative of the Fund. The publication shall contain information about the

new Sub-Fund/Class or the relevant undertaking for collective investment and shall be made at least 30 days before the
last date for requesting redemption or, as the case may be, conversion without any charge other than those retained by
the Fund to meet disinvestment costs. The shareholders right to request redemption or, as the case may be, conversion
of their shares shall become effective from the moment that the shareholders of the merging fund and those of the
receiving fund have been informed of the proposed merger in accordance with the above paragraph and shall cease to
exist five working days before the date for calculating the exchange ratio.

Once this period elapses, the decision to merge becomes binding on all shareholders who have not yet availed them-

selves of the abovementioned facility.

For such Class meetings, there shall be no quorum requirement and decisions may be taken by a simple majority of

the Shares of the Class concerned.

In case of an amalgamation with an unincorporated mutual fund (fonds commun de placement) or a foreign collective

investment undertaking, decisions of the Class meeting of the Class concerned shall be binding only for holders of Shares
that have voted in favour of such amalgamation.

If following a compulsory redemption of all Shares of one or more Classes, payment of the redemption proceeds

cannot be made to a former shareholder, then the amount in question shall be deposited with the Caisse de Consignations
within 9 (nine) months following the decision of liquidation for the benefit of the person(s) entitled thereto until the
expiry of the period of limitation. The close of liquidation of one or more Sub-Funds or Classes shall in principle also take
place within 9 (nine) months from the Board of Directors’ decision to liquidate the Sub-Funds or Classes.

If there have been created, as more fully described in Article 6 hereof, within the same Class of Shares two categories,

the dissolution rules set out above shall apply, mutatis mutandis, to such categories of Shares.

Where funds have designated a management company, legal, advisory or administrative costs associated with the

preparation of the merger shall not be charged to the merging or receiving fund, or to any of their shareholders.

Further details on cross-border as well as domestic funds/sub-funds mergers are disclosed in Chapter 8 of the 2010

Law.

In the event that the Board of directors determines that it is required by the interests of the Shareholders of the

relevant Sub-Fund/Class or that a change in the economic or political situation relating to the Sub-Fund/Class concerned
has occurred which would justify it, the reorganization of the Sub-Fund, by means of a division into two or more Classes
and Categories, may be decided by the Board of directors. Such decision will be published in the same manner as described
above and, in addition, the publication will contain information in relation to the two or more new Classes. Such publication
will be made within one month before the date on which the reorganization becomes effective in order to enable the
Shareholders to request redemption of their Shares, free of charge before the operation involving division into two or
more Classes becomes effective.

Art. 27. Investment in one or more other Sub-Funds of the Fund. Pursuant to Article 181 (8) of the Law, any sub-fund

of the Fund may subscribe, acquire and/or hold securities to be issued or issued by one or more sub-funds of the Fund
without the Fund being subject to the requirements of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended,
with respect to the subscription, acquisition and/or the holding by a company of its own shares, under the conditions
however that:

- the target Sub-Fund does not, in turn, invest in the Sub-Fund who has invested in this target Sub-Fund; and
- no more than 10% of the assets that the target Sub-Funds whose acquisition is contemplated may be invested in

shares of other target Sub-Funds of the Fund; and

3624

L

U X E M B O U R G

- voting rights, if any, attaching to the relevant securities are suspended for as long as they are held by the Sub-Fund

concerned and without prejudice to the appropriate processing in the accounts and the periodic reports; and

- in any event, for as long as these securities are held by the Fund, their value will not be taken into consideration for

the calculation of the net assets of the Fund for the purposes of verifying the minimum threshold of the net assets imposed
by the 2010 Law; and

- there is no duplication of management, subscription or repurchase fees between those at the level of the Sub-Fund

of the Fund having invested in the target Sub-Fund, and this target Sub-Fund.

Art. 28. Master-feeder structures. Subject to the respect of the provisions of Chapter 9 of the 2010 Law, the Fund or

one of its sub-fund may become a feeder Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (“UCITS”) by
investing at least 85% of its assets in shares of another UCITS or any of its sub-funds (the “Master UCITS”).

The Fund or one of its sub-fund may also become a Master UCITS if is not itself a feeder UCITS, if it does not hold

units of a feeder UCITS and if it has among its shareholders at least one feeder UCITS.

The adoption of one of the other structure by the Fund shall be subject to the prior approval of the Luxembourg

Supervisory Authority, the Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”), and shall be specifically disclosed
in the Fund’s Prospectus and marketing communications.

Further details on master-feeder structures may be found in Chapter 9 of the 2010 Law.

Art. 29. Amendment of the Articles of Incorporation. These Articles of Incorporation may be amended from time to

time by a meeting of Shareholders, subject to the quorum and voting requirements provided by the laws of Luxembourg.
Any amendment affecting the rights of the holders of Shares of any Sub-Fund/Class vis-à-vis those of any other Class shall
be subject, further, to the said quorum and majority requirements in respect of each such relevant Sub-Fund/Class.

Art. 30. Formation and Operating costs. The Fund shall bear its formation costs, including notably the costs for the

preparation and printing of the sales documents, notary fees, registration costs with administrative and stock exchange
authorities, the costs for printing certificates and all other expenses in relation with the incorporation and the launching
of the Fund.

Sub-funds will bear their own launch, liquidation and restructuring costs.
These costs may be amortized over a period not exceeding the first 5 financial years.
The Fund shall bear all operating costs, such as provided in Article 22 paragraph B.

Art. 31. General Provisions. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in ac-

cordance with the 2010 Law and the law of 10 

th

 August 1915 on commercial companies, as amended.

<i>Subscription and payment

The subscriber has subscribed for the number of Shares and has paid in cash the amount as mentioned hereafter:

Subscribed

capital

Number

of Shares

BANOR SIM S.P.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 31,000

310

The possibility to choose the classification of these Shares is given at the end of the initial subscription period.
Evidence of the above payment has been given to the undersigned notary.

<i>Expenses

The expenses which shall result from the organization of the Fund are estimated at approximately 2,500.- EUR.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in articles 26, 26-3 and 26-5 of the law of August tenth,

nineteen hundred and fifteen on commercial companies, as amended, have been observed.

<i>Resolutions of the sole shareholder

The above named person representing the entire subscribed capital has immediately proceeded to hold an extraor-

dinary general meeting of Shareholders which resolved as follows:

<i>First resolution

The following are elected as directors for a term to expire at the close of the annual general meeting of Shareholders

which shall deliberate on the annual accounts of the Fund as at 31 

st

 December, 2015:

- Mr Giacomo Mergoni, Director, Banor Capital Ltd, 16, Berkeley Street, London W1J 8DZ, United-Kingdom born in

Viareggio (Italy) on 23 

rd

 February 1977,

- Mr Sylvain Feraud, General Manager, Casa4Funds SA, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, born in Villeurbanne

(France) on 26 

th

 April 1976,

3625

L

U X E M B O U R G

- Mrs Margherita Balerna Bommartini, Head of Operations &amp; Branch Manager, Casa4Funds SA Luxembourg, Swiss

Branch, Paradiso, Via L. Zuccoli 19, CH-6900 Lugano, born in Lugano (Switzerland) on 4 

th

 September 1967.

<i>Second resolution

The following is elected as auditor or a term to expire at the close of the annual general meeting of Shareholders

which shall deliberate on the annual accounts of the Fund as at 31 

st

 December, 2015:

Deloitte Audit, société à responsabilité limitée, 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg (RCS B.67895).

<i>Third resolution

The registered office of the Fund is fixed at 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg.

Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg on the date named at the beginning of this deed.
The undersigned Notary who understands and speaks English states herewith that upon request of the above appearing

person, the present deed is worded in English.

This deed having been read to the appearing person, who is known to the notary by his surname, Christian name, civil

status and residence, said person appearing signed together with us, the notary, this original deed.

Signé: P. ZAMPERINI et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 4 décembre 2014. Relation: LAC/2014/57886. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur ff.

 (signé): C. FRISING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 15 décembre 2014.

Référence de publication: 2015002035/760.
(150002024) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2015.

Textiles Meyer S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1618 Luxembourg, 17, rue des Gaulois.

R.C.S. Luxembourg B 67.516.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014200647/9.
(140223689) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2014.

Extreme Growth Fund SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement

Spécialisé.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 2, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 148.599.

DISSOLUTION

L'an deux mille quatorze, le douze décembre.
Par-devant Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

a comparu:

Monsieur Chris Oberhag, avec adresse professionnelle at 13, avenue François Clément, L-5612 Mondorf-les-Bains,
agissant en qualité de mandataire spécial de l’actionnaire unique Superior SPF, une société anonyme de droit luxem-

bourgeois, ayant son siège social à 18, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 70.234,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 12 décembre 2014.
Ladite procuration restera, après avoir été paraphée «ne varietur» par le mandataire et le notaire soussigné, annexée

aux présentes pour être soumise avec elles à la formalité de l’enregistrement.

Laquelle partie comparante, représentant l’intégralité du capital, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
1. Que la société anonyme Extreme Growth Fund SICAV-SIF, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 148.599, ayant son siège social au 2, rue Heinrich Heine, L-1720
Luxembourg (ci-après la «Société»), a été constituée le 6 octobre 2009 suivant acte reçu par Maître Marc Lecuit, notaire
de résidence à Mersch, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2100 du 26 octobre 2009, et
les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié du 14 juin 2013, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés
et Associations numéro 2021 du 21 août 2013 (la «Société»);

3626

L

U X E M B O U R G

2. Que le capital social de la Société est variable;
3. Par la présente, Superior SPF, préqualifiée, agissant en sa qualité d’actionnaire unique prononce la dissolution de la

Société et sa mise en liquidation. Superior SPF assume la fonction de liquidateur de la Société;

4. Superior SPF déclare que l’activité de la Société a cessé, que les passifs connus de la Société ont été payés ou

provisionnés, que la Société n’a plus de passif, que l’actionnaire unique est investi de tout l’actif et qu’il s’engage expres-
sément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé ou
inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; par conséquent la liquidation de la Société est à considérer comme
faite et clôturée;

5. Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs, et au commissaire de la Société et au liquidateur.
6. Que les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq ans auprès d’Hauck &amp; Aufhäuser

Investment Gesellschaft, 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, connu du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom

usuel, état et demeure, ce dernier a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: C. Oberhag, M. Loesch.
Enregistré à Remich, le 24 décembre 2014. REM/2014/2867. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): P. MOLLING.

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 7 janvier 2015.

Référence de publication: 2015003014/45.
(150002856) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2015.

Tishman Speyer Lumiere Holdings I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.022.725,00.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 114.242.

In the year two thousand and fourteen, on the fifteenth day of the month of December.
Before Maître Léonie GRETHEN, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared

Tishman Speyer Lumiere Holdings I S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) esta-

blished and existing under Luxembourg law, having its registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of one million twenty-two thousand seven hundred twenty-five Euro
(EUR 1,022,725.-), and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 114242, esta-
blished pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, then notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
on January 12, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations number 884 dated May 5,
2006 and whose bylaws have been last amended pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, prenamed, on April 2,
2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations number 1001 dated May 13, 2009 (the
“Absorbing Company”),

represented by Mr Mustafa NEZAR, lawyer, by virtue of a special power of attorney granted by the board of managers

of the Absorbing Company of November 4, 2014, which remained attached to the merger proposal received by the
undersigned notary on 5 November 2014.

The appearing party requested the undersigned notary to state as follows:
1. The merger proposal relating to the merger of the Absorbing Company and its wholly owned direct subsidiary

Tishman Speyer Lumiere Holdings (Lux) S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) esta-
blished and existing under Luxembourg law, having its registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of five million Euro (EUR 5,000,000.-), and registered with the Lu-
xembourg Trade and Companies Register under number B 147008, established pursuant to a deed of Maître Joseph
Elvinger, prenamed, on June 26, 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations number 1452
dated July 28, 2009 and whose bylaws have not been amended since (the “Absorbed Company” and together with the
Absorbing Company, the “Merging Companies”), was published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associa-
tions number 3406 of November 15 2014 (the “Merger Proposal”);

2. The Merger Proposal provides that the merger between the Merging Companies shall become effective on December

15, 2014;

3. In accordance with article 273 of the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended (the “Law”), the

merger shall become effective vis-à-vis third parties after the publication of the present enactment deed in the Mémorial
in accordance with article 9 of the Law;

3627

L

U X E M B O U R G

4. The Merger Proposal and the annual accounts of the last three (available) financial years (where relevant) of the

Merging Companies have been made available at the registered office of the Merging Companies at least one month before
the effective date of the merger between the Merging Companies;

5. None of the shareholders of the Absorbing Company has requested that a general meeting of shareholder(s) be

called pursuant to article 279(1)c) of the Law; and

6. The Absorbed Company ceased to exist on December 15, 2014.
The certificate of the Absorbing Company certifying the availability of the documents pursuant to article 264 of the

Law and the absence of a request for the convening of a general meeting of the shareholders of the Absorbing Company
pursuant to article 279(1) c) of the Law, has been submitted to the notary and shall, after having been initialled ne varietur
by the appearing party and the undersigned notary, remain attached to the present deed to be filed with the registration
authorities.

The appearing party has thus requested the undersigned notary to issue the present certificate pursuant to article 273

of the Law.

<i>Statement

Pursuant to article 273 of the Law, the undersigned notary hereby declares that he made the necessary verifications

and certifies the existence and the validity of acts and formalities carried out by the Merging Companies and that in
consequence the conditions of article 279 of the Law have been fulfilled.

The undersigned notary who understands and speaks English acknowledges that, at the request of the party hereto,

this deed is drafted in English, followed by a French translation; at the request of the same party, in case of divergences
between the English and the French version, the English version shall prevail.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day before mentioned.
The document having been read to the appearing person, who is known to the notary by his surname, first name, civil

status and residence, the said person signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L’an deux mille quatorze, le quinzième jour du mois de décembre,
Par-devant Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu:

Tishman Speyer Lumiere Holdings I S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit Luxembourgeois, ayant son

siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, avec un capital social d’un
million vingt-deux mille sept cent vingt-cinq Euro (EUR 1,022,725.-), enregistrée auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés  de  Luxembourg  sous  le  numéro  B  114242,  constituée  par  acte  de  Maître  Joseph  Elvinger,  alors  notaire  de
résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, reçu en date du 12 janvier 2006, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et des Associations numéro 884 du 5 mai 2006 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par
acte de Maître Joseph Elvinger, prénommé, en date du 2 avril 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des
Associations numéro 1001 du 13 mai 2009 (la Société Absorbante),

représentée  par  Monsieur  Mustafa  NEZAR,  juriste,  demeurant  professionnellement  à  Luxembourg,  en  vertu  d’un

mandat spécial accordé par résolutions du conseil de gérance de la Société Absorbante en date du 4 novembre 2014, qui
est restée attachée au projet de fusion reçu par le notaire soussigné le 5 novembre 2014.

La partie comparante a requis le notaire soussigné d’acter comme suit:
1. Le projet de fusion relatif à la fusion de la Société Absorbante et sa filiale directe entièrement détenue Tishman

Speyer Lumiere Holdings (Lux) S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit Luxembourgeois, ayant son siège
social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, avec un capital social de cinq
millions d’Euro (EUR 5.000.000.-), enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 147008, constituée par acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, reçu en date du 26 juin 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations numéro 1452
du 28 juillet 2009 et dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis (la «Société Absorbée» et ensemble avec la Société
Absorbante, les «Sociétés Fusionnantes»), a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations numéro
3406 du 15 novembre 2014 (le «Projet de Fusion»);

2. Le Projet de Fusion prévoit que la fusion entre la Société Absorbée et la Société Absorbante devient effective au

15 décembre 2014;

3. Conformément à l’article 273 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée (la «Loi»),

la fusion deviendra effective vis-à-vis des tiers après la publication du présent constat de fusion au Mémorial conformément
à l’article 9 de la Loi;

4. Le Projet de Fusion et les comptes annuels des trois derniers exercices (disponibles) (si pertinent) des Sociétés

Fusionnantes ont été mis à disposition au siège social des Sociétés Fusionnantes au moins un mois avant la date effective
de la fusion entre les Sociétés Fusionnantes;

3628

L

U X E M B O U R G

5. Aucun des actionnaires de la Société Absorbante n’a demandé la convocation d’une assemblée générale conformé-

ment à l’article 279(1)c) de la Loi; et

6. La Société Absorbée a cessé d’exister le 15 décembre 2014.
Le certificat de la Société Absorbante certifiant conformément à l’article 264 de la Loi la disponibilité des documents

et l’absence de demande de convocation de l’assemblée générale de la Société Absorbante conformément à l’article 279
(1) c) de la Loi, a été soumis au notaire et restera, après avoir été signé ne varietur par la partie comparante et le notaire
soussigné, annexé au présent acte pour être soumis avec celui-ci aux autorités d’enregistrement.

La partie comparante a ainsi demandé au notaire soussigné d’émettre le présent certificat conformément à l’article

273 de la Loi.

<i>Déclaration

Conformément à l’article 273 de la Loi, le notaire soussigné déclare par la présente qu’il a effectué les vérifications

nécessaires et certifie l’existence et la validité des actes et formalités entrepris par les Sociétés Fusionnantes et que de
ce fait les conditions de l’article 279 de la Loi ont été remplies.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglaise reconnaît que, à la demande de la partie comparante cet acte est

rédigé en anglais suivi d’une traduction française; à la demande de la même partie, en cas de divergences entre la version
anglaise et la version française, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, fait à Luxembourg date entête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, connu du notaire instrumentant par son

nom, prénom usuel, état et demeure, ladite personne a signé ensemble avec le notaire l’original du présent acte.

Signé: Nezar, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 17 décembre 2014. Relation: LAC/2014/60805. Reçu soixante-quinze euros

(75,00 €).

<i>Le Receveur (signé): Irène Thill.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Luxembourg, le 31 décembre 2015.

Référence de publication: 2015004119/119.
(150003498) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2015.

Silverton Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 151.303.

<i>Extrait de l'assemblée générale ordinaire de l'actionnaire unique de la Société Silverton Properties S.à.r.l qui s'est tenue à Luxembourg

<i>le 10 décembre 2014.

<i>Résolution unique

L'assemblée générale décide de remplacer pour une durée illimitée les gérants actuels à savoir, Madame Francesca

Docchio et Monsieur Xavier Mangiullo, démissionnaires, ainsi que Monsieur Simeone Raccah par Monsieur Xavier MAN-
GIULLO, Monsieur Julien NICAUD et Monsieur Alberto BONFIGLIO.

Le nouveau conseil de gérance est donc composé comme suit:
- Xavier Mangiullo, né à Hayange (FR) le 8 septembre 1980, résident professionnellement à L-1420 Luxembourg 5,

avenue Gaston Diderich;

- Julien NICAUD, né à Metz (FR) ne le 4 juin 1981 résident professionnellement à L-1420 Luxembourg 5, avenue

Gaston Diderich;

- Alberto BONFIGLIO né à Milano (I) le 18 avril 1958 , résident professionnellement à Via Camperio 9 , I-20123 Milano
Les pouvoirs accordés au nouveau conseil d'administration restent limités aux opérations ordinaires, et ne compren-

nent  pas  les  pouvoirs  de  vendre,  en  tout  ou  en  partie,  des  participations,  des  biens  immobiliers  ainsi  que  pour
l'enregistrement de nouvelles inscriptions hypothécaires

Luxembourg, le 10 décembre 2014.

Pour copie conforme
<i>Pour le conseil de gérance
Xavier MANGIULLO
<i>Gérant

Référence de publication: 2014200552/27.
(140223840) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2014.

3629

L

U X E M B O U R G

Haus + Technik s.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9765 Mecher (Clervaux), Maison 3B.

R.C.S. Luxembourg B 98.007.

Uewen &amp; Feier, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9709 Clervaux, 20, route de Marnach.

R.C.S. Luxembourg B 191.445.

L'an deux mille quinze, le sixième jour du mois de janvier.
Par-devant Maître Jean-Paul MEYERS, notaire de résidence à Rambrouch, Grand-Duché de Luxembourg, agissant en

remplacement de Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg, lequel
dernier restera dépositaire du présent acte,

Ont comparu:

Le gérant unique, Monsieur Nico METTENDORFF, né le 23 décembre 1963, demeurant à L-9714 Clervaux, 4, rue

Klatzewee, de la société à responsabilité limitée HAUS + TECHNIK s.àr.l. ayant son siège social à L-9765 Mecher/Cler-
vaux, Maison 3B, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 98.007;

Le gérant unique, Monsieur Nico METTENDORFF, né le 23 décembre 1963, demeurant à L-9714 Clervaux, 4, rue

Klatzewee, de la société à responsabilité limitée UEWEN &amp; FEIER S.à r.l., ayant son siège social à L-9709 Clervaux, 20,
route de Marnach, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 191.445.

Lesquels gérants ont requis le notaire instrumentant d'acter en la forme authentique le projet de transfert d’une partie

du patrimoine professionnel dont ils ont arrêté les termes et modalités, sur base d’un rapport écrit détaillé expliquant et
justifiant du point de vue juridique et économique le projet de transfert tel que prescrit par l’article 308bis-10 de la loi
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifié, ledit rapport, après avoir été signé «ne varietur» par le
comparant et le notaire soussigné, restera annexé au présent acte pour être soumis en même temps avec lui aux formalités
de l’enregistrement.

<i>Dispositions du projet de transfert d’une partie du patrimoine professionnel

Description de la société qui transfère une partie du patrimoine professionnel et présentation du transfert du patri-

moine professionnel:

- La société à responsabilité limitée HAUS + TECHNIK HAUS s.à r.l. est une société à responsabilité limitée ayant son

siège social à L-9765 Mecher/Clervaux, Maison 3B et elle est inscrite depuis le 01 décembre 1989 au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro B.98.007. (Ci-après dénommée «la Société»). Elle a été
constituée par acte reçu par le notaire Maître Christine DOERNER, notaire de résidence à Bettembourg, en date du 15
novembre 1989. Son capital social s’élève à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit euro (EUR
12 394,68.-) représenté par cinq cents (500) parts sociales de vingt-quatre virgule sept huit neuf trois six euro (EUR
24,78936.-) chacune, toutes intégralement souscrites et libérées.

- La société à responsabilité limitée HAUS + TECHNIK s.à r.l. est une société à responsabilité limitée qui a pour objet:
«La société a pour objet l’exploitation d’une entreprise d’installation de chauffage, de climatisation de ventilation et de

sanitaire ainsi que d’installation électrique de tout genre, avec le commerce en gros et en détail de matériaux et d’articles
de la branche, ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se
rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le déve-
loppement.»

- Dans le cadre d'une restructuration estimée nécessaire, le gérant unique de la Société HAUS + TECHNIK s.à r.l. a

considéré que le transfert d’une partie du patrimoine professionnel de la Société à la société à responsabilité limitée
UEWEN &amp; FEIER S.à r.l. ayant son siège social à L-9709 Clervaux, 20, route de Marnach, inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 191.445, constituée suivant acte reçu par le notaire Maître Edouard
DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch, en date du 30 octobre 2014 et pas encore publié au Mémorial, était le moyen
le plus approprié pour atteindre le résultat voulu en toute neutralité fiscale.

La société à responsabilité limitée HAUS + TECHNIK s.à r.l. veut se concentrer à l’avenir essentiellement sur le

développement de ses branches d’activité principales, notamment les installations de chauffage, de climatisation, de ven-
tilation, de sanitaire et d’électrique.

- Dès lors, le gérant unique de la Société HAUS + TECHNIK s.à r.l. a décidé de proposer à l’associé unique de la

Société le transfert d’une partie du patrimoine professionnel en l’occurrence le commerce en gros et en détail de maté-
riaux et d’articles de poêles et de l’installation de poêles à la société à responsabilité limitée UEWEN &amp; FEIER S.àr.l., ayant
son siège social à L-9709 Clervaux, 20, route de Marnach, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le
numéro B 191.445. Elle a été constituée par acte reçu par Maître Edouard DELOSCH de résidence à Diekirch en date
du 30 octobre 2014. Son capital social s’élève à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500.-) représenté par cent (100)
parts sociales de cent vingt-cinq euros (EUR 125.-) chacune, toutes intégralement souscrites et libérées. Au 1 

er

 janvier

3630

L

U X E M B O U R G

2015, date effectif du transfert du patrimoine professionnel, son capital s’élève à douze mille cinq cents euros (EUR
12.500.-).

La société à responsabilité limitée UEWEN &amp; FEIER S.à r.l. est une société à responsabilité limitée qui a pour objet:
«La société a pour objet l’exploitation d’une entreprise d’installation de poêles, de chauffage, de climatisation, de

ventilation, de sanitaire, de ramonage, de tubage, de fumisterie ainsi que d’installation électrique de tout genre, avec le
commerce en gros et en détail de matériaux et d’articles de la branche, ainsi que toutes opérations industrielles, com-
merciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou
qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement.»

- Le gérant de la société UEWEN &amp; FEIER S.à r.l. estime et ceci conformément à l’objet social de la société UEWEN

&amp; FEIER S.à r.l. que le transfert d’une partie du patrimoine professionnel de la société à responsabilité limitée HAUS +
TECHNIK s.à r.l. à la société UEWEN &amp; FEIER S.à.r.l. permet de développer la branche d’activité professionnelle principale
de la Société UEWEN &amp; FEIER S.à r.l. en l’occurrence le commerce en gros et en détail de matériaux et d’articles de
poêles et de l’installation de poêles

- Dès lors, le gérant unique de la société à responsabilité limitée UEWEN &amp; FEIER S.à r.l a décidé de proposer à l’associé

unique de la société à responsabilité limitée UEWEN + FEIER S.àr.l d’accepter le transfert d’une partie du patrimoine
professionnel en l’occurrence le commerce en gros et en détail de matériaux et d’articles de poêles et de l’installation
de poêles de la société à responsabilité limitée HAUS + TECHNIK s.à r.l., ayant son siège social à L-9765 Mecher/Clervaux,
Maison 3B, à la Société UEWEN &amp; FEIER S.à r.l..

- Sur base du présent projet de transfert d’une partie du patrimoine professionnel et conformément à l’article 308bis,

6 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, la Société transférera une partie du patrimoine
professionnel à la société à responsabilité limitée UEWEN &amp; FEIER S.àr.l. ayant son siège social à L-9709 Clervaux, 20,
route de Marnach, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 191.445 à l’occasion
d'une assemblée générale extraordinaire (l’ «Assemblée Générale Extraordinaire») qui se tiendra devant le notaire Maître
Edouard DELOSCH au minimum un mois après la publication du présent projet de transfert d’une partie du patrimoine
professionnel au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Conditions et modalités du transfert d’une partie du patrimoine professionnel:

<i>Condition préalable:

<i>Date effective:

Les opérations de la Société HAUS + TECHNIK s.à r.l. qui transfère une partie de son patrimoine professionnel seront

considérées comme accomplies pour le compte de la Société à compter du 1 

er

 janvier 2015 dans la mesure où elles se

rapportent aux actifs et passifs de la partie du patrimoine professionnel transférée.

<i>Partie du patrimoine professionnel transférée:

Conformément à l’article 308bis-8(2), un inventaire des éléments du patrimoine des actifs et passifs qui seront trans-

férés à la société à responsabilité limitée UEWEN &amp; FEIER S.à r.l., ayant son siège social à L-9709 Clervaux, 20, route de
Marnach, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 191.445, est dressé ci-après:

Actif:
Stock Clervaux: 223 884,26€
Travaux en cours Clervaux: 7.870,00€
Tableau d’amortissement Clervaux: 122.450,40€
Clients Clervaux: 64.310,91€
Compte associé Nico Mettendorff: 5.700,82€
Compte BCEE LU94 0019 3655 7084 9000: 105.201,29€
Caisse Clervaux: 6.818,09€
Total Actif 536.235,77€
Passif:
Fournisseurs Clervaux: 132.363,65€
Prêt BCEE LU78 0011 1362 0085 8540: 190.151,64€
Prêt BCEE LU28 0011 1362 0209 3280: 30.283,31€
Bénéfice reporté: 170.000,00€
Total Passif: 522.798,60€
Ces éléments du patrimoine transféré à la société UEWEN &amp; FEIER S.à r.l., présentent un excédent d’actifs (Art.

308bis-8(3)).

La valeur totale des actifs et passifs transférés est de treize mille quatre cent trente-sept virgule dix-sept euro (EUR

13.437,17.-).

Conséquences du transfert d’une partie du patrimoine professionnel:

3631

L

U X E M B O U R G

Ce transfert d’une partie du patrimoine professionnel entraînera de plein droit toutes les conséquences prévues par

l’article 308bis, 13 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

<i>Contreprestation

En contrepartie, la société à responsabilité limitée UEWEN &amp; FEIER S.à r.l. déclare reprendre le contrat de prêt portant

le numéro LU78 0011 1362 0085 8540 et qui présente un montant à rembourser au 1 

er

 janvier 2015 de 190.151,64 EUR,

que HAUS + TECHNIK a conclu en date du 24 octobre 2011 avec l’institut de crédit Banque et Caisse d’épargne de
l’état.

UEWEN &amp; FEIER S.à r.l. déclare tenir quitte et indemne HAUS + TECHNIK s.à r.l. de toute condamnation éventuelle

en relation avec le remboursement de ce prêt, en ce qui concerne les mensualités à payer à partir du 1 

er

 janvier 2015.

UEWEN &amp; FEIER S.à r.l. déclare également reprendre le contrat de prêt portant le numéro LU28 0011 1362 0209

3280 et qui présente un montant à rembourser au 1 

er

 janvier 2015 de 30.283,31 EUR que HAUS + TECHNIK a conclu

en date du 23 novembre 2012 avec l’institut de crédit Banque et Caisse d’épargne de l’état.

UEWEN &amp; FEIER S.à r.l. déclare tenir quitte et indemne HAUS + TECHNIK s.à r.l. de toute condamnation éventuelle

en relation avec le remboursement de ce prêt, en ce qui concerne les mensualités à payer à partir du 1 

er

 janvier 2015.

<i>Modifications au projet:

Un ou plusieurs points du présent projet de transfert d’une partie du patrimoine professionnel pourra toujours être

modifié ou complété par l’Assemblée Générale Extraordinaire.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare attester la légalité du présent projet de transfert, conformément aux dispositions de la

loi sur les sociétés commerciales, tel que modifiée.

Dont acte, fait et passé à Rambrouch, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: N. METTENDORFF, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 07 janvier 2015. Relation: DAC/2015/193. Reçu douze (12.-) euros.

<i>Le Receveur (signé): THOLL.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Diekirch, le 08 janvier 2015.

Référence de publication: 2015003783/141.
(150003919) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2015.

CARRON S.A., société de gestion de patrimoine familial, Société Anonyme - Société de Gestion de Pa-

trimoine Familial.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 72.298.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la société qui s'est tenue en date du 15 décembre

<i>2014 au siège social:

Il est décidé de renouveler le mandat des membres du conseil d'administration jusqu'à l'assemblée générale annuelle

des actionnaires de la société qui se tiendra en l'an 2017.

a) Madame Kathryn Erin Lattin, née le 09/10/1980 à Brisbane (Australie) résidant 24 Charmaine Street, Moorooka Qld

4105, Australie et

b) Monsieur Ian Bruce Cheney, né le 05/09/1951 à Melbourne (Australie) résidant 40 Wentworth Parade, Balmoral

Qld 4171 (Australie), et comme d'administrateur délégué.

Les mandats des administrateurs et administrateur-délégué arriveront à échéance à l'assemblée générale qui se tiendra

en l'an 2017.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Administrateurs

Référence de publication: 2014199967/21.
(140224080) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2014.

3632

L

U X E M B O U R G

Pro-Vision SD S.A., Société Anonyme,

(anc. Pro-Vision SD S.à r.l.).

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 128.479.

Les comptes annuels au 31 mars 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014200494/9.
(140224107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2014.

Procom-Immobilière S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4660 Differdange, 24, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 133.076.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014200495/9.
(140224402) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2014.

ROLLINGER Toiture, Société Anonyme.

Siège social: L-7333 Steinsel, 70, rue des Prés.

R.C.S. Luxembourg B 117.653.

Rollinvest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7333 Steinsel, 70, rue des Prés.

R.C.S. Luxembourg B 152.514.

L'an deux mille quatorze, le trente décembre.
Par devant Maître Jean-Paul Meyers, notaire de résidence à Rambrouch,

Ont Comparu

1) le conseil d’administration de la société anonyme «ROLLINGER Toiture», établie et ayant son siège social à 70, rue

des Prés, L-7333 Steinsel, immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B
117653, et

2) le conseil d’administration de la société anonyme «ROLLINVEST S.A.», établie et ayant son siège social à 70, rue

des Prés, L-7333 Steinsel, immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B
152514,

tout deux ici représentés par M. Gernot Kos, demeurant professionnellement à Luxembourg, sur base de deux pro-

curations  spéciales  sous  seing  privé  données  par  les  deux  conseils  d’administration  en  date  du  18  décembre  2014,
lesquelles procurations, après avoir été signées «ne varietur» par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront
annexées au présent acte pour être formalisé avec lui.

Le mandataire des deux prédits conseils d’administration prie le notaire d’acter le projet de scission suivant, en dé-

clarant que lesdits conseils d’administration des sociétés «Rollinger Toiture» et «Rollinvest s.a.» proposent de réaliser la
scission partielle par absorption de la société anonyme «ROLLINGER Toiture» au profit de la société anonyme «ROL-
LINVEST S.A.», afin d’effectuer dans le même groupe une opération de restructuration conformément à la loi du 19
décembre 2008 portant révision du régime applicable à certains actes de société en matière de droits d’enregistrement,
etc., en transférant une branche d’activité de la société «ROLLINGER Toiture» à la société-mère «ROLLINVEST S.A.».

PROJET DE SCISSION

Description de la société à scinder et présentation de la scission:
«ROLLINGER Toiture» (ci-après la "Société Scindée") est une société anonyme luxembourgeoise établie et ayant son

siège social à 70, rue des Prés, L-7333 Steinsel, immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 117653, constituée par acte reçu par le notaire Émile Schlesser, de résidence à Luxembourg, en date
du 29 juin 2006, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 1701 du 12 septembre 2006, et dont
les statuts ont été modifiés la dernière fois suivant acte reçu par le notaire Carlo WERSANDT, de résidence à Luxem-
bourg, en date du 23 mars 2012, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 1189 du 11 mai 2012.

Son capital social s'élève à huit cent mille euros (800.000,- EUR), divisé en huit cents (800) actions d'une valeur nominale

de mille euros (1.000,- EUR) chacune, toutes souscrites et intégralement libérées.

3633

L

U X E M B O U R G

Les huit cents (800) actions représentatives du capital social sont les seuls titres existant actuellement émis par la

Société Scindée et il n'existe ni obligations, ni parts bénéficiaires, ni titres sous quelque désignation que ce soit conférant
à leur porteur un droit de vote ou un quelconque droit préférentiel.

Le conseil d'administration de la Société Scindée a décidé de proposer aux actionnaires de la Société Scindée, la scission

de celle-ci par l’apport d’une branche d’activité dans le cadre d’une opération de restructuration à la prénommée société
anonyme «ROLLINVEST S.A.» (ci-après dénommée «Société Absorbante»), ce qui est pareillement approuvé et soutenu
par le conseil d’administration de cette dernière et proposé aux actionnaires de la Société Absorbante.

Sur base du présent projet de scission et conformément aux articles 287 et 289 et suivants de la loi modifiée du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales (ci-après la "Loi"), ainsi qu'à la loi du 19 décembre 2008 portant révision du
régime applicable à certains actes de société en matière de droits d’enregistrement, etc., il est proposé que la Société
Scindée transfère, sans liquidation, à la Société Absorbante, à l’occasion d'une assemblée générale extraordinaire («l’As-
semblée Générale Extraordinaire») à tenir à Luxembourg devant notaire au minimum un mois après la publication du
présent projet de scission au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, l’actif et le passif de la branche d’activité
consistant en la détention et l’exploitation du patrimoine immobilier professionnel de l’entreprise, à savoir: le bail em-
phytéotique existant entre la Société Scindée et la Société Absorbante (initialement conclu entre la Société Scindée et la
société anonyme «Rollimmo S.A.» en vertu d’un acte reçu par Maître Émile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg,
en date du 6 avril 2009, transcrit au premier bureau des hypothèques à Luxembourg le 28 avril 2009, volume 2189,
numéro 13, et repris par la Société Absorbante lors de l’acquisition du terrain en question par cette dernière suivant acte
de vente acte reçu par Maître Émile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 8 avril 2011, transcrit au
premier bureau des hypothèques à Luxembourg le 5 mai 2011, volume 2356, numéro 74), portant sur les parcelles sises
70, rue des Prés, L-7333 Steinsel, et inscrites au cadastre sous la commune de Steinsel, section B de Steinsel, numéro
783/1094, lieu-dit «Beim Kirschenbaeumchen», pré, contenant 14,40 ares, numéro 785/320, même lieu-dit et nature,
contenant 9,20 ares, numéro 788/1562, même lieu-dit et nature, contenant 15,20 ares, numéro 790/327, même lieu-dit
et nature, contenant 19,30 ares, numéro 794/3434, même lieu-dit et nature, contenant 11,85 ares; le hall de production
et de stockage y érigé par la Société Scindée dans le cadre du bail emphytéotique, et les créances et dettes y rattachées,
tel que détaillé plus loin et tel que formant la branche d’activité immobilière d’exploitation de la Société Scindée.

Aux termes de la Scission, le prédit bail emphytéotique prendra fin par confusion dans le chef de la Société Absorbante

de la qualité d’emphytéote et de propriétaire du fonds.

<i>Conditions et modalités de la scission

<i>Attribution des actions - Absence de rapports

Les actions émises par la Société Absorbante en contrepartie de la branche d’activité transférée seront intégralement

attribuées aux actionnaires de la Société Scindée proportionnellement à leurs détentions respectives, conformément à
l’article 287 de la loi concernant les sociétés commerciales.

Ainsi que le permettent les dispositions de l’article 296 (1) et (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les

sociétés commerciales, les actionnaires des deux sociétés ont renoncé d’ores et déjà aux exigences prévues par les articles
293, 294 et 295 concernant le rapport écrit détaillé expliquant et justifiant la scission et en particulier le rapport d’échange
des actions, le rapport écrit formel sur la scission établi par un réviseur d'entreprises et destiné aux actionnaires et l’état
comptable à soumettre aux actionnaires.

<i>Modalités de remise des actions des sociétés bénéficiaires:

Les actions nouvelles de la Société Absorbante seront remises aux actionnaires de la Société Scindée à la date d'ap-

probation de la scission par l’assemblée générale des actionnaires.

<i>Date effective:

Les opérations de la Société Scindée quant à la branche d’activité concernée plus amplement détaillée ci-avant, seront

considérées comme accomplies pour le compte de la Société Absorbante à compter du 1 

er

 janvier 2015 dans la mesure

où elles se rapportent à ladite branche d’activité transférée.

<i>Droit aux bénéfices

Les actions nouvelles de la Société Absorbante confèrent le droit de participer aux bénéfices de la Société Absorbante

à compter de la date d'approbation de la scission projetée par les présentes.

<i>Avantages particuliers

Aucun avantage particulier n'est attribué à l’expert au sens de l’article 294 de la loi sur les sociétés commerciales, ni

aux membres des conseils d'administration, ni au réviseur d'entreprises de la société à scinder.

<i>Modes d’évaluation et répartition des éléments du patrimoine

Conformément à l’article 289 h) de la Loi, les éléments du patrimoine actif et passif de ladite branche d’activité à

transmettre de plein droit à la Société Absorbante par l’effet de la scission, que le conseil d’administration a décidé

3634

L

U X E M B O U R G

d’évaluer à leur valeur nette comptable sur base des comptes non-audités de ROLLINGER TOITURE S.A. en date du 31
octobre 2014, sont répartis de la manière suivante:

Rolllinger

Toiture S.A.

(avant Scission)

Rolllinger

Toiture S.A.

(après Scission

À transférer à

Rollinvest s.a.

ACTIF
Immobilisations corporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.436.657,66 €

332.651,08 € 6.104.006,58 €

Immobilisations financières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.050,00 €

7.050,00 €

Stocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.739.497,14 € 2.739.497,14 €

Créances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.650.402,62 € 2.650.402,62 €

Avoirs en caisse et banques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.428,80 €

2.428,80 €

Comptes de régularisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.463,25 €

-2.463,25 €

Total du Bilan (Actif) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.836.036,22 € 5.734.492,89 € 6.101.543,33 €
PASSIF
Capital propres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

800.000,00 €

510.000,00 €

290.000,00 €

Réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.586,52 €

4.586,52 €

Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-237.693,53 € -237.693,53 €

Résultat de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65.226,14 €

65.226,14 €

Provisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.000,00 €

12.000,00 €

Dettes envers des établissements de crédit . . . . . . . . . . . . . . . .

7.081.180,42 € 2.690.513,99 € 4.390.666,43 €

Autres dettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.689.859,77 € 2.689.859,77 €

Dettes envers actionnaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.420.876,90 €

0,00 € 1.420.876,90 €

Total du Bilan (Passif) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.836.036,22 € 5.734.492,89 € 6.101.543,33 €

Il n’y a pas eu d’événements postérieurs à la date d’arrêté comptable du 31 octobre 2014 qui pourraient avoir une

influence significative sur la valeur de la branche d’activité à transférer.

<i>Rapport du Réviseur

Le réviseur d'entreprises agréé Madame Claudine Wilhelm, représentant la société à responsabilité limitée «Statera

Audit», enregistrée en tant que cabinet de révision agréé, sous le numéro d’identification 126, établie et ayant son siège
social au L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 156.148, est désignée aux fins d'établir le rapport sur les apports autres qu'en numéraire dans le cadre de
l’article 26-1 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

<i>Conséquences de la scission

Cette scission partielle par absorption entraîne de plein droit toutes les conséquences prévues par l’article 303 de la

Loi.

Ainsi, par l’effet de la scission, l’ensemble du patrimoine actif et passif de la branche d’activité concernée plus amplement

détaillée ci-avant de la Société Scindée est de plein droit transmis à la Société Absorbante, et ce tant entre les sociétés
participant à la scission qu'à l’égard des tiers. Les actionnaires de la Société Scindée deviennent actionnaires de la Société
Absorbante au moment de la réalisation de la scission.

La Société Scindée n’est pas dissoute mais continue sans interruption de la personnalité morale avec le restant de ses

actifs et passifs, abstraction faite de ceux relevant de la branche d’activité transférée.

<i>Modalités de scission

a. La Société Absorbante deviendra propriétaire des actifs et passifs de la branche d’activité transférée, dans l’état où

ceux-ci se trouvent à la date d'effet sans droit de recours contre la Société Scindée pour quelque raison que ce soit.

b. La Société Scindée garantit à la Société Absorbante que les créances cédées dans le cadre de la scission sont certaines

mais elle n'assume aucune garantie quant à la solvabilité des débiteurs cédés.

c. La Société Absorbante sera redevable de tous impôts, taxes, charges et frais, tant ordinaires qu'extraordinaires qui

grèveront ou pourront grever les éléments d'actif et de passif qui lui sont cédés par l’effet de la présente scission.

d. La Société Absorbante assurera à partir de la date d'effet tous les droits et toutes les obligations qui sont attachés

aux éléments d'actif et de passif respectifs qui lui sont attribués et elle continuera d'exécuter, dans la mesure de la
répartition effectuée, tous les contrats en vigueur à la date d'effet sans possibilité de recours contre la Société Scindée.
Ainsi la Société Absorbante paiera en principal et en intérêts toutes dettes et toutes obligations liées aux éléments de
passif qui lui sont attribués conformément à la répartition prévue.

e. Les droits et créances transmises à la Société Absorbante sont transférés à cette société avec toutes les garanties

tant réelles que personnelles qui y sont attachées. La Société Absorbante sera ainsi subrogée, sans qu'il y ait novation,

3635

L

U X E M B O U R G

dans tous les droits réels et personnels de la Société Scindée en relation avec tous les biens et contre tous les débiteurs
sans exception, le tout conformément à la répartition des éléments du bilan.

La subrogation s'appliquera plus particulièrement à tous les droits d'hypothèque, de saisie, de gage et autres droits

similaires, de sorte que la Société Absorbante sera autorisée à procéder à toutes les notifications, à tous les enregistre-
ments, renouvellements et renonciations à ces droits d'hypothèque, de saisie, de gage et autres.

f. La Société Absorbante renoncera formellement à toutes actions résolutoires qu'elles auront contre la Société Scindée

du fait que la Société Absorbante assumera les dettes, charges et obligations de la Société Scindée.

g. La scission entraînera de plein droit les conséquences prévues par l’article 303 de la loi du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales.

h. La Société Absorbante procédera à toutes les formalités nécessaires ou utiles pour donner effet à la scission et la

Société Scindée procédera à toutes les formalités nécessaires à la cession des avoirs et obligations à la Société Absorbante.

i. Le projet de scission sera à la disposition des actionnaires de la Société Scindée et de la Société Absorbante au siège

social de la Société Scindée au moins un mois avant la date de l’assemblée générale ensemble avec les comptes annuels
et le rapport de gestion des deux derniers exercices.

<i>Modifications au projet

Le présent projet de scission peut être modifié ou complété par l’Assemblée Générale Extraordinaire appelée à l’ap-

prouver.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire instrumentant, par nom, prénoms, état et demeure, il a signé

avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Kos, Jean-Paul Meyers.
Enregistré à Redange/Attert, le 30 décembre 2014. Relation: RED/2014/2708. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): Kirsch

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins d’enregistrement auprès du R.C.S.L. et de la

publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Rambrouch, le 31 décembre 2014.

Jean-Paul MEYERS.

Référence de publication: 2015004046/173.
(150003768) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2015.

UBM CP Holdings No 4 S.à.r.l, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1224 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 192.802.

STATUTES

In the year two thousand and fourteen, on the first day of the month of December.
Before Maître Cosita DELVAUX, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

UBM CP Holdings No 1 S.C.S, a company incorporated and existing under the laws of Luxembourg and having its

registered office at 17, boulevard Prince Henri, L- 1724 Luxembourg, in the process of being registered with the Register
of Commerce and Companies in Luxembourg (“UBM CP Holdings No 1”), represented by United CP Holdings S.à r.l., a
private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of Luxembourg, having its
registered office at L-1724 Luxembourg, 17, Boulevard Prince Henri, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the
Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés under number B 70850 and having a share capital of USD 63,390,000,
in its capacity as unlimited member and manager of UBM CP Holdings No 1, itself represented by Maître Mariya Gadz-
halova, maître en droit, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney dated 1 

st

 December

2014 (such power of attorney, after being signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall remain
attached hereto to be registered together with the present deed).

The appearing party has requested the undersigned notary to draw up the articles of incorporation of a limited liability

company ("société à responsabilité limitée") which is hereby established as follows:

Art. 1. A limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name of UBM CP Holdings No 4 S.àr.l.

is hereby formed by the appearing party and all persons who will become members, that will be governed by these articles
of incorporation and by the relevant legislation.

Art. 2. The object of the Company is the holding of participations and interests, in any form whatsoever, in Luxembourg

and foreign companies, partnerships or other entities, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner

3636

L

U X E M B O U R G

as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, receivables, bonds, debentures, notes and other securities
of any kind, and the acquisition, ownership, administration, development, disposal and management of its portfolio. The
Company may also hold interests in partnerships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.

The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds, debentures, notes

and other debt instruments convertible or not.

In a general fashion it may lend funds and grant assistance (by way of loans, advances, guarantees, securities, collateral,

mortgage, pledge or otherwise) to companies or other entities in which the Company has an interest or which forms
part of the group of companies to which the Company belongs, take any controlling and supervisory measures and carry
out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

The Company may use any techniques, legal means and instruments to manage its investments efficiently, including the

entry into any forward transactions as well as techniques and instruments designed to protect the Company against credit
risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

Finally, the Company can perform all operations connected directly or indirectly with the accomplishment of its cor-

porate object.

Art. 3. The Company is established for an unlimited period.

Art. 4. The registered office of the Company is in Luxembourg. It may be transferred to any other place within the

Grand-Duchy of Luxembourg by collective decision of the members.

Art. 5. The capital of the Company is fixed at twelve thousand five hundred Euros (€12,500) divided into twelve

thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one Euro (€1) each.

Art. 6. Each share entitles its owner to a proportionate right in the Company's assets and profits.

Art. 7. Shares are freely transferable among members. Except if otherwise provided by law, the share transfer inter

vivos to non-members is subject to the consent of at least seventy five percent of the Company's capital. In the case of
the death of member who is a natural person, the share transfer to non-members is subject to the consent of no less
than seventy five (75%) percent of the votes of the surviving members. In any event the remaining members have a pre-
emption right which has to be exercised within thirty days from the refusal of transfer to a non-member according to
the provision laid down by article 189 of the law of 10 

th

 August 1915 on commercial companies, as amended (the "Law

of 1915").

Art. 8. The Company is managed by one or several managers who need not to be members. They are appointed and

removed from office by the general meeting of members, which determines their powers and the term of their mandates,
and which resolves at the majority of the capital. They may be re-elected and may be revoked with or without cause (ad
nutum) at any time.

Any manager may participate in any meeting of the board of management by conference-call or by other similar means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one
another. A meeting may also be held by conference call only. The participation in a meeting by these means is equivalent
to a participation in person at such meeting. Managers may be represented at meetings of the board by another manager
without limitation as to the number of proxies which a manager may accept and vote. The quorum for a meeting of
managers shall be half of the managers in office. Decisions of the board of management are validly taken by the approval
of the majority of the managers of the Company, present or represented at the meeting.

The board of management may, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means

when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety
will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including circular
resolutions,  may  be  conclusively  certified  or  an  extract  thereof  may  be  issued  under  the  individual  signature  of  any
manager.

Vis-à-vis third parties the manager or managers have the most extensive powers to act on behalf of the Company in

all circumstances and to do and authorise all acts and operations relative to the Company. The Company will be bound
by the individual signature of any manager or by the sole signature of any person or persons to whom such signatory
powers shall have been delegated by the managers.

Art. 9. The managers are not held personally liable for the indebtedness of the Company. As agents of the Company,

they are responsible for the correct performance of their duties.

Art. 10. Each member may take part in collective decisions. Each member has a number of votes equal to the number

of shares each member owns and may validly act at the meeting through a special proxy.

Art. 11. Collective decisions are only valid if they are adopted by the votes representing more than half of the capital.

However, decisions concerning the amendment of the articles of incorporation are taken by a majority of the members
representing three quarters of the capital.

3637

L

U X E M B O U R G

Art. 12. The fiscal year begins on 1 

st

 January and ends on 31 

st

 December of the same year save for the first fiscal

year which shall start on the date of incorporation and end on 31 December 2014.

Art. 13. Every year as of 31 

st

 December, the annual accounts are drawn up by the managers.

Art. 14. The financial statements are at the disposal of the members at the registered office of the Company.

Art. 15. Out of the net profit five (5%) percent shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to

be compulsory when the reserve amounts to ten percent of the capital of the Company.

The members may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the managers

showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not
exceed profits realised since the end of the last fiscal year increased by profits carried forward and distributable reserves
but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles
of incorporation.

The balance may be distributed to the members upon decision of a general meeting of the members.
The share premium account may be distributed to the members upon decision of a general meeting of the members.

The members may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal reserve account.

Art. 16. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need

not to be members and who are appointed by the general meeting of the members who will specify their powers and
remunerations.

Art. 17. If, and as long as one member holds all the shares, the Company shall exist as a single member Company,

pursuant to article 179 (2) of the Law of 1915; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are
applicable.

Art. 18. For anything not dealt with in the present articles of incorporation, the members refer to the relevant legis-

lation.

<i>Subscription and payment

The articles of incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the appearing party

UBM CP Holdings No 1, acting through its unlimited partner United CP Holdings S.àr.l.,

here represented as stated here above by Maître Mariya Gadzhalova (prenamed),
declared to subscribe to all twelve thousand five hundred (12,500) shares of the Company with nominal value of one

Euro (EUR 1) each and to pay them up in full together with a share premium for a total subscription price of one million
five  hundred  sixty-six  thousand  six  hundred  thirty-two  Euro  (EUR  1,566,632)  through  the  contribution  in  kind  of  a
receivables from Think Services Game Group Germany GmbH (formerly UBM TechWeb Europe), a Gesellschaft mit
Beschränkter Haftung, having its registered office at Kaiser-Wilhelm-Str. 30, 12247 Berlin, Germany with registration
under number HRB 119171, of an aggregate amount of one million five hundred sixty-six thousand six hundred thirty-
two Euro (EUR 1,566,632) (the “Contribution in Kind”).

The Contribution in Kind to the Company was valued at of one million five hundred sixty-six thousand six hundred

thirty-two Euro (EUR 1,566,632) in a valuation report dated 1 December 2014 prepared by the founder shareholder
(which after being signed ne varietur will be annexed hereto to be registered with this deed).

Proof of the existence of the Contribution in Kind and the transfer to the Company of that Contribution in Kind was

shown to the undersigned notary.

Out of the value of the Contribution in Kind an amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR12, 500) was

allocated to the share capital account of the Company, an amount of one thousand two hundred and fifty Euro (EUR
1,250) was allocated to the legal reserve and the remainder of one million five hundred fifty-two thousand eight hundred
eighty-two Euro (EUR 1,552,882) was allocated to share premium.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for by Article 183 of the law of August 10 

th

 1915, on

commercial companies, as amended, have been observed.

<i>Expenses, Valuation

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately Euro 1,200.-.

<i>Extraordinary general meeting

The single shareholder has forthwith taken immediately the following resolutions:
1. The registered office of the Company is fixed at 17, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
2. The number of managers of the Company is set at three and the following persons are appointed as managers of

the Company for an unlimited duration:

3638

L

U X E M B O U R G

- Mr Paul de Haan, manager, born on 20 

th

 June 1970 in Alkmaar (the Netherlands), professionally residing at 17,

boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

- Mr Nicholas Michael Perkins, born on 16 

th

 September 1969 in Bridgend, United Kingdom, professionally residing at

245, Blackfriars Road, Ludgate House, GB-SE1 9UY London; and

- Mr Maarten van de Vaart, born on 2 December 1959, in Castricum, the Netherlands, with professional address at

17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing person, the present deed is worded

in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by its name, first

name, civil status and residence, said proxyholder signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille quatorze, le premier jour du mois de décembre,
Par devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

UBM CP Holdings No 1 S.C.S, une société constituée et existant sous le droit luxembourgeois, et ayant son siège

social au 17, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, en cours d’être enregistrée auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés à Luxembourg («UBM CP Holdings No 1»), représentée par United CP Holdings S.àr.l. une société à
responsabilité limitée constituée sous les lois du Luxembourg, ayant son siège social au, 17, Boulevard Prince Henri L-1724
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de et à
Luxembourg sous le numéro B 70850 et ayant un capital social de 63.390.000 USD, agissant en sa capacité d’associé-
commandité et de gérant de UBM CP Holdings No 1, elle-même représentée par Maître Mariya Gadzhalova, maître en
droit, demeurant professionnellement à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une procuration en date
du 1 

er

 décembre 2014 (laquelle après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant restera

annexé au présent pour être enregistrés ensemble avec lui).

Lequel comparant a demandé au notaire soussigné d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité

limitée qu'il constitue par les présentes:

Art. 1 

er

 .  Il est formé par le comparant et toutes personnes qui deviendront par la suite associés, une société à

responsabilité limitée au nom de UBM Holdings No 4 S.à r.l. qui sera régie par les présents statuts et les dispositions
légales afférentes.

Art. 2. L'objet de la Société est de détenir des participations et intérêts sous quelque forme que ce soit, dans des

sociétés luxembourgeoises et étrangères, société de personnes ou de toute autre entreprise, l’acquisition par achat,
souscription, ou par tout autre moyen, de même que par la vente, l’échange ou autrement d'actions, de créances, d'obli-
gations, de certificats de créance, ou autres valeurs mobilières de toute espèce, et l’acquisition, la détention, l’adminis-
tration, le développement, la disposition et la gestion de son portefeuille. La Société peut également détenir des intérêts
dans des sociétés de personnes et exercer son activité par l’intermédiaire de succursales luxembourgeoises ou étrangères.

La Société peut emprunter sous toute forme et procéder par voie de placement privé à l’émission d'obligations, de

certificats de créance, d’avoir et d’autre type d’instruments de dettes convertibles ou non.

D'une manière générale elle peut prêter des fonds et prêter assistance (par l’intermédiaire de prêts, avances, garanties,

sûreté, nantissement, hypothèque, gage ou autrement) à toute société ou autre entité dans laquelle la Société à un intérêt
ou  qui  fait  partie  du  groupe  de  sociétés  dans  lequel  la  Société  appartient,  prendre  toute  mesure  de  contrôle  et  de
surveillance et effectuer toute opération qu'elle juge utile dans l’accomplissement et le développement de son objet.

La Société peut utiliser toutes techniques, moyens légaux et instruments pour gérer ses investissements efficacement,

en incluant l’entrée dans toutes transactions ainsi que techniques et instruments destinés à protéger la Société contre les
risques de crédit, le risque de conversion monétaire, les risques de taux d’intérêts et autres risques.

Finalement, la Société peut effectuer tous types d’opérations en relation directe ou indirecte avec l’accomplissement

de son objet social.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de

Luxembourg en vertu d'une décision collective des associés.

Art. 5. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500 €) divisé en douze mille cinq cents

(12.500) parts sociales d’une valeur nominale de un euro (1 €) chacune.

Art. 6. Chaque part donne droit à une part proportionnelle de l’actif social et des bénéfices.

3639

L

U X E M B O U R G

Art. 7. Les parts sociales sont librement transférables entre associés. Sauf dispositions contraires de la loi, les parts

sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément donné par au moins soixante-
quinze pourcent du capital social. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort d’un associé étant
une personne physique à des non-associés que moyennant l’agrément des associés représentant au moins soixante-quinze
(75%) pour cent des droits appartenant aux survivants. En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de pré-
emption. Ils doivent l’exercer endéans trente jours à partir de la date du refus du transfert à un non-associé conformément
aux dispositions de l’article 189 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée (la
«Loi de 1915»).

Art. 8. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Ils sont nommés et révoqués par

l’assemblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions, et qui statue à la majorité
du capital. Ils sont rééligibles et ils sont révocables avec ou sans cause (ad nutum) à tout moment.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou d'autres moyens de

communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les unes les
autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence téléphonique. La participation à
une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. Tout gérant peut être représenté
à une réunion du conseil de gérance par un autre gérant sans qu'il n’y ait de limitation quant au nombre de procurations
en vertu desquelles un gérant peut accepter et voter. Le quorum pour une réunion du conseil de gérance est de la moitié
des gérants en fonction. Les décisions du conseil de gérance sont valablement prises par l’approbation de la majorité des
gérants de la Société, présent ou représenté à la réunion.

Le conseil de gérance peut, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

par écrit, par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. L'ensemble consti-
tuera les documents circulaires dûment exécutés faisant foi de la décision intervenue.

Le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société dans toutes les

circonstances et pour faire et autoriser les actes et opérations relatifs à l’objet de la Société. La Société sera engagée par
la signature seule et individuelle de chacun des gérants ou par la signature individuelle de toute personne à qui de tels
pouvoirs de signature auront été délégués par les gérants.

Art. 9. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle. Comme mandataires,

ils sont responsables de l’exécution de leur mandat.

Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre

de parts sociales que chaque associé possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de
procuration spéciale.

Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 12. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de la même année sauf pour l’année sociale

qui commence à la date de constitution de la Société et qui se termine le 31 décembre 2014.

Art. 13. Chaque année, la gérance établit les comptes annuels au 31 décembre.

Art. 14. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels.

Art. 15. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq (5%) pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve légale jusqu'à

ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé par les

gérants duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à dis-
tribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal ou, pour le premier
exercice social, la date de constitution, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des
pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.

Le solde peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale des associés.
La réserve de prime d'émission peut être distribuée aux associés par décision prise en assemblée générale des associés.

Les associés peuvent décider d'allouer tout montant de la prime d'émission à la réserve légale.

Art. 16. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par l’assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 17. Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société

est une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la Loi de 1915; dans cette éventualité, les articles 200-1 et
200-2, entre autres, de la même loi sont d'application.

Art. 18. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

3640

L

U X E M B O U R G

<i>Souscription et libération

Les statuts de la Société ayant été ainsi établis par le comparant UBM CP Holdings No 1 S.C.S., agissant par son associé-

commandité United CP Holdings, S.à r.l.,

représentée par Maître Mariya Gadzhalova (prénommée),
a déclaré souscrire et intégralement libérer toutes les douze mille cinq-cents (12.500) parts sociales de la Société

ensemble avec une prime d'émission pour un montant de souscription totale d’un million cinq cent soixante-six mille six
cent trente-deux Euros (1.566.632 EUR) par l’apport en nature d’une créance de Think Services Game Group Germany
GmbH (anc. UBM TechWeb Europe), a Gesellschaft mit Beschränkter Haftung, ayant son siège social à Kaiser-Wilhelm-
Str. 30, 12247 Berlin, Germany avec numéro d’immatriculation HRB 119171, d’un montant total d’un million cinq cent
soixante-six mille six cent trente-deux Euros (1.566.632 EUR) (l “Apport en Nature”)

L’Apport en Nature à la Société a été évalué à un montant d’un million cinq cent soixante-six mille six cent trente-

deux Euros (1.566.632 EUR) dans un rapport d’évaluation daté du 1 

er

 décembre 2014 préparé par l’associé fondateur

(lequel après avoir été signé ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant restera annexé au présent aux fins
de l’enregistrement).

La preuve de l’existence de l’Apport en Nature et du transfert à la Société de cet Apport en Nature a été donnée au

notaire soussigné.

Du montant de l’Apport en Nature, un montant de douze mille cinq-cents euros (12.500 EUR) a été alloué au capital

social de la Société, un montant de mille deux cent cinquante Euros (1.250 EUR) a été alloué à la réserve légale de la
Société, le solde d’un montant de un million cinq cent cinquante-deux mille huit cent quatre-vingt-deux Euros (1.552.882
EUR) étant alloué au poste prime d’émission.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues par l’article 183 des lois sur les sociétés (loi du 18

septembre 1933) se trouvent remplies.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison des présentes est évalué à environ EUR 1.200,-.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt, l’associé unique a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est fixé au 17, boulevard du Prince Henri, L- 1724 Luxembourg.
2. Le nombre de gérants est fixé à trois et les personnes suivantes sont nommées comme gérants de la Société pour

une durée illimitée:

- Monsieur Paul de Haan, gérant, né le 20 juin 1970 à Alkmaar (Pays-Bas) demeurant professionnellement à 17, bou-

levard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

- Monsieur Nicholas Michael Perkins, né le 16 septembre 1969 à Bridgend (Royaume Uni), demeurant professionnel-

lement à 245, Blackfriars Road, Ludgate House, GB-SE1 9UY London; and

- Monsieur Maarten van de Vaart, né le 2 décembre 1959, à Castricum (Pays-Bas) demeurant professionnellement à

17, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire par son nom, prénom,

état civil et résidence, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: M. GADZHALOVA, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 04 décembre 2014. Relation: LAC/2014/57720. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 décembre 2014.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2014201282/295.
(140225100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2014.

3641

L

U X E M B O U R G

Merym S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 90.125.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014201093/9.
(140225084) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2014.

Palladio S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.

R.C.S. Luxembourg B 192.811.

STATUTS

L'an deux mil quatorze, le huit décembre.
Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. Monsieur Jean BIRGEN, consultant, né le 28 mai 1944 à Waldbillig, demeurant à L-1529 Luxembourg, 65, rue Raoul

Follereau.

2. Madame Oriana, Céline BIRGEN, employée privée, née le 7 juin 1992 à Niederkorn, demeurant à L-2210 Luxem-

bourg, 84, Boulevard Napoléon 1 

er

 .

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme

qu'ils déclarent constituer entre eux:

Titre I 

er

 . Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et en particulier la loi

modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (ci-après dénommée la «Loi») ainsi que par les présents statuts
(ci-après dénommés les «Statuts»).

La Société existe sous la dénomination de «PALLADIO S.A.» (ci-après dénommée la «Société»).

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de

Luxembourg par simple décision du Conseil d'Administration.

Par simple décision du Conseil d'Administration, la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que tou-
tefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du
siège, restera luxembourgeoise. Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des
tiers par l'un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société a pour objet les opérations d'achats et de vente en gros et détails de vêtements de tout genre et

accessoires de mode.

La Société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et
le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un

portefeuille se composant de tous titres et valeurs mobilières de toute origine, participer à la création, au développement
et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option
d'achat et de toute autre manière, tous titres et droits, les aliéner par vente, échange ou autrement, octroyer aux en-
treprises auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter

caution pour d'autres personnes morales ou physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La Société pourra encore effectuer toutes opérations commerciales, industrielles ou financières susceptibles de favo-

riser l'accomplissement des activités décrites ci-dessus.

3642

L

U X E M B O U R G

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (31.000,- EUR) représenté par TROIS CENT DIX

(310) actions d'une valeur nominale de CENT EUROS (100,-EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la Loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit par une décision de l'assemblée générale des actionnaires prise

en accord avec les dispositions applicables au changement des Statuts.

La Société peut procéder au rachat de ses propres actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les

dispositions de l'article 49-2 de la Loi, sous les conditions prévues par la Loi.

Titre III. Administration

Art. 6. En cas de pluralité d'actionnaires, la Société doit être administrée par un conseil d'administration (Ci-après

dénommé le "Conseil d'Administration") composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Si la Société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est

constaté que la Société est composée de seulement un seul actionnaire restant, le Conseil d'Administration peut être
réduit à un Administrateur (Ci-après dénommé l'"Administrateur Unique") jusqu'à la prochaine assemblée générale des
actionnaires constatant l'existence de plus d'un actionnaire.

Une personne morale peut être membre du Conseil d'Administration ou peut être l'Administrateur Unique de la

Société.  Dans  un  tel  cas,  un  représentant  permanent  de  cette  personne  morale  devra  être  nommé  ou  confirmé  en
conformité avec la Loi.

Les Administrateurs ou l'Administrateur Unique sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour une

période n'excédant pas six ans et sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale des
actionnaires. Ils restent en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés. Les Administrateurs élus sans indi-
cation de la durée de leur mandat, seront réputés avoir été élus pour un terme de six ans.

En cas de vacance du poste d'un administrateur pour cause de décès, de démission ou autre raison, les administrateurs

restants  nommés  de  la  sorte  peuvent  se  réunir  et  pourvoir  à  son  remplacement,  à  la  majorité  des  votes,  jusqu'à  la
prochaine assemblée générale des actionnaires portant ratification du remplacement effectué.

Art. 7. Le Conseil d'Administration choisit parmi ses membres un président.
Le Conseil d'Administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, sans qu'un administrateur ne puisse représenter
plus d'un administrateur, laquelle procuration peut être donnée par lettre, télégramme, télex ou fax.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, télex ou fax, ces trois derniers étant à

confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une

décision prise à une réunion du Conseil d'Administration.

Art. 8. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et

de disposition qui rentrent dans l'objet social conformément à l'article 4 ci-dessus.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la Loi et les Statuts à l'assemblée

générale.

Tout Administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la Société, dans une opération soumise à l'approbation du

Conseil d'Administration, est tenu d'en prévenir le conseil et de faire mentionner cette déclaration dans le procès-verbal
de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Lors de la prochaine assemblée générale, avant tout vote sur
d'autres résolutions, il est spécialement rendu compte des opérations dans lesquelles un des Administrateurs aurait eu
un intérêt opposé à celui de la Société.

En cas d'un Actionnaire Unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre

la Société et son Administrateur ayant un intérêt opposé à celui de la Société.

Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la Loi.

Art. 9. Les résolutions sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage, le président a une voix prépondérante.

Art. 10. Envers les tiers, la Société sera engagée en toutes circonstances, en cas d'Administrateur Unique, par la

signature unique de son Administrateur Unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de
deux Administrateurs ou par la signature unique de toute personne à qui le pouvoir de signature aura été délégué par le
Conseil d'Administration ou par l'Administrateur Unique de la Société, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

3643

L

U X E M B O U R G

Envers les tiers, la Société sera engagée en toutes circonstances, en cas d'Administrateur-délégué nommé pour la

gestion et les opérations courantes de la Société et pour la représentation de la Société dans la gestion et les opérations
courantes, par la seule signature de l'Administrateur-délégué, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 11. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs

qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Le conseil d'administration peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des

affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Le premier administrateur-délégué peut être nommé par l'assemblée générale des actionnaires.
La délégation à un administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

Art. 12. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. Surveillance

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.

Titre V. Assemblée générale

Art. 14. La Société peut avoir un actionnaire unique lors de sa constitution. Il en est de même lors de la réunion de

toutes ses actions en une seule main. Le décès ou la dissolution de l'actionnaire unique n'entraîne pas la dissolution de la
société.

S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des

actionnaires et prend les décisions par écrit.

En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la Société.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs à l'activité de la Société.

Toute assemblée générale sera convoquée conformément aux dispositions légales.
Elles doivent être convoquées sur la demande d'Actionnaires représentant dix pour cent du capital social.
Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir pris connaissance de l'agenda de

l'assemblée, ils pourront renoncer aux formalités préalables de convocation.

Un actionnaire peut être représenté à l'assemblée générale des actionnaires en nommant par écrit (ou par fax ou par

e-mail ou par tout moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être un actionnaire et est par conséquent autorisé à
voter par procuration.

Chaque action donne droit à un vote.
La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la Société est détenue par plusieurs propriétaires

en propriété indivise, la Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule
personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Les actionnaires sont autorisés à participer à une assemblée générale des actionnaires par visioconférence ou par des

moyens de télécommunications permettant leur identification et sont considérés comme présent, pour les conditions de
quorum et de majorité. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation
effective à l'assemblée dont les délibérations sont retransmises de façon continue.

Sauf dans les cas déterminés par la Loi ou les Statuts, les décisions prises par l'assemblée ordinaire des actionnaires

sont adoptées à la majorité simple des voix, quelle que soit la portion du capital représentée.

Lorsque la société a un actionnaire unique, les décisions doivent être prises par résolutions écrites.
Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier une disposition des Statuts

ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié du capital est présente ou représentée et que l'ordre du jour
indique les modifications statutaires proposées.

Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une seconde assemblée peut être convoquée, dans les formes

prévues par les Statuts ou par la loi. Cette convocation reproduit l'ordre du jour, en indiquant la date et le résultat de la
précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement, quelle que soit la proportion du capital représenté.
Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, doivent être adoptées par une majorité de deux tiers des
Actionnaires présents ou représentés.

Cependant, la nationalité de la Société ne peut être changée et l'augmentation ou la réduction des engagements des

actionnaires ne peuvent être décidées qu'avec l'accord unanime des actionnaires et sous réserve du respect de toute
autre disposition légale.

Art. 15. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convo-

cations, le deuxième mardi du mois de juin à 11.00 heures.

3644

L

U X E M B O U R G

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 16. L'année sociale commence le premier (1 

er

 ) janvier et finit le trente et un (31) décembre de chaque année.

Art. 17. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 18. La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.
Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, nommés

par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 19. Pour tous les points non spécifiés dans les présents Statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la Loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription - Libération

Les Statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les comparants, représentés comme mentionnés ci-avant, déclarent

souscrire les actions comme suit:

1. Monsieur Jean BIRGEN, prénommé, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cent cinquante-cinq (155) actions,
2. Madame Oriana BIRGEN, prénommée, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cent cinquante-cinq (155) actions,
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

trois cent dix (310) actions.

Toutes les actions ont été intégralement libérées, de sorte que la somme de TRENTE ET UN MILLE EUROS (31.000,-

EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2014.
La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2015.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 nouveau de la Loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille vingt-cinq (1.025,-Eur).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants précités, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués, et,

après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ont pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre d'administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2. sont appelés aux fonctions d'administrateurs, leurs mandats expireront lors de l'assemblée générale de l'année 2020:
Monsieur Jean BIRGEN, prénommé,
Monsieur Raymond BIRGEN, retraité, né le 26 juillet 1939 à Mamer, demeurant à L-2210 Luxembourg, 84, Boulevard

Napoléon 1 

er

 .

Madame Oriana BIRGEN, prénommée.
3. Est appelé aux fonctions de commissaire son mandat expirant lors de l'assemblée générale de l'année 2020:
Monsieur Andrea BIRGEN, étudiant, né le 09 mai 1991 à Niederkorn, demeurant à L-2210 Luxembourg, 84, Boulevard

Napoléon 1 

er

 .

4. Le siège social de la société est fixé à L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.
5. Le Conseil d'Administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d'administrateur-

délégué. Est alors nommé aux fonctions d'administrateur-délégué:

Monsieur Raymond BIRGEN, prénommé.

3645

L

U X E M B O U R G

<i>Remarque:

Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu'avant toute activité commerciale de la société

présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et

demeures, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J. BIRGEN, O.C. BIRGEN, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 10 décembre 2014. Relation: LAC/2014/59115. Reçu soixante-quinze euros

(EUR 75,-).

<i>Le Receveur

 (signé): I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 décembre 2014.

Référence de publication: 2014201167/219.
(140225245) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2014.

Radical Euro-Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 130.521.

L'an deux mille quatorze, le dix-neuf novembre.
Par devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

S'est réunie

l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de «Radical Euro-Services S.A.», une société anonyme ayant son

siège social au 10A, rue Henri Schnadt L-2530 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte reçu
par M aître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16 juillet 2007, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 2040 du 20 septembre 2007,

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 130.521 (la «Société»).
L'assemblée  a  été  déclarée  ouverte  sous  la  présidence  de  Madame  Virginie  PIERRU,  clerc  de  notaire,  demeurant

professionnellement au 12, rue Jean Engling L-1466 Luxembourg.

Le président a désigné comme secrétaire Monsieur Christian DOSTERT, clerc de notaire, demeurant professionnel-

lement au 12, rue Jean Engling L-1466 Luxembourg.

L'assemblée a choisi comme scrutateur Monsieur Jesus Maria RAMIREZ RODRIGUEZ, administrateur de sociétés,

demeurant professionnellement au 7 Dorfstrasse CH-6390 Engelberg (Suisse).

Le bureau ainsi constitué, le président a exposé et prié le notaire soussigné d'acter ce qui suit:
Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Création de deux catégories d’administrateurs (administrateur A et Administrateur B) de la Société et fixation de

la nouvelle composition du conseil d’administration de la Société.

2.- Ajout d’un alinéa à l’article 6 des statuts de la Société comme suit: «Ils seront nommés par l’assemblée dans deux

groupes différents A et B.»

3.- Modification de l’article 7 des statuts de la Société comme suit: «Le conseil d'administration est investi des pouvoirs

les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans
l’objet social, et tout ce qui n'est pas réservé à l’assemblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa
compétence. Il peut notamment accepter des compromis, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou
sans paiement.

Le conseil d'administration est autorisé à procéder au versement d'acomptes sur dividendes aux conditions et suivant

les modalités fixées par la loi.

Lorsqu’il existe deux groupes d’administrateurs A et B, le Conseil d’Administration ne pourra délibérer ou agir vala-

blement que si les décisions du Conseil d’Administration sont prises par un administrateur de la catégorie A et par un
administrateur de la catégorie B.

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et/
ou agents, associés ou non-associés.

3646

L

U X E M B O U R G

En cas de décès prématuré d’un ou plusieurs administrateurs aboutissant de fait à l’absence d’administrateurs de deux

catégories, le Conseil d’Administration s’abstiendra de prendre toute décision sauf pour les stricts besoins de la gestion
quotidienne de la Société et ce, jusqu’à ce que les actionnaires aient pu se réunir afin de procéder à la désignation du ou
des nouveaux administrateurs dans la catégorie concernée. De plus, même dans ce cas, toute décision du Conseil d’Ad-
ministration prise pendant la période transitoire devrait être ratifiée par les actionnaires.

La Société sera engagée, en toutes circonstances (y compris dans le cadre de la gestion journalière), vis-à-vis des tiers

(i) par la signature d’un administrateur unique en présence d’un administrateur unique, ou (ii) la signature conjointe d’un
administrateur A et d’un administrateur B, ou (ii) par la signature individuelle du délégué à la gestion journalière, ou (iii)
par les signatures conjointes de toutes personnes ou l’unique signature de toute personne à qui de tels pouvoirs de
signature auront été délégués par le Conseil d'Administration, et ce, dans les limites des pouvoirs qui leur auront été
conférés.».

I. L’actionnaire unique de la Société présent ainsi que le nombre d'actions détenues par lui sont indiqués sur une liste

de présence; cette liste de présence, après avoir été signée «ne varietur» par l’actionnaire unique, les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

II. L'intégralité du capital social était représentée à l’assemblée et l’actionnaire unique représenté a déclaré avoir eu

connaissance de l’ordre du jour qui lui a été communiqué au préalable et a renoncé à son droit d’être formellement
convoqué.

III. L’assemblée était par conséquent régulièrement constituée et a pu délibérer valablement sur tous les points portés

à l’ordre du jour.

Que l’assemblée a pris, chaque fois à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution:

L’assemblée générale décide de créer deux (2) catégories d’administrateurs (administrateur A et Administrateur B)

de la Société et fixe la composition du conseil d’administration de la Société, comme suit:

<i>Administrateur A:

Monsieur Jesus Maria RAMIREZ RODRIGUEZ, né le 06 février 1945 à Bilbao (Espagne), demeurant au 7 Dorfstrasse

CH-6390 Engelberg (Suisse).

<i>Administrateurs B:

- Madame Marie-Hedwige EL KHOURY, né le 17 mars 1974 à Kafarabida, Liban, et demeurant professionnellement à

L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt,

- Monsieur Marco CASAGRANDE, né le 14 février 1979 à Padova (Italie), demeurant professionnellement au 10A rue

Henri M. Schnadt L-2530, et

<i>Deuxième résolution:

L’assemblée générale décide d’ajouter un alinéa à l’article 6 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

« Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans

son sein. Ils sont nommés pour un terme n’excédant pas six années. Ils seront nommés par l’assemblée dans deux groupes
différents A et B.»

<i>Troisième résolution:

L’assemblée générale modifie l’article 7 des statuts de la Société pour refléter les résolutions ci-dessus pour lui donner

la teneur suivante:

« Art. 7. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n'est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment accepter des compromis,
transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d'administration est autorisé à procéder au versement d'acomptes sur dividendes aux conditions et suivant

les modalités fixées par la loi.

Lorsqu’il existe deux groupes d’administrateurs A et B, le Conseil d’Administration ne pourra délibérer ou agir vala-

blement que si les décisions du Conseil d’Administration sont prises par un administrateur de la catégorie A et par un
administrateur de la catégorie B.

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et/
ou agents, associés ou non-associés.

En cas de décès prématuré d’un ou plusieurs administrateurs aboutissant de fait à l’absence d’administrateurs de deux

catégories, le Conseil d’Administration s’abstiendra de prendre toute décision sauf pour les stricts besoins de la gestion
quotidienne de la Société et ce, jusqu’à ce que les actionnaires aient pu se réunir afin de procéder à la désignation du ou

3647

L

U X E M B O U R G

des nouveaux administrateurs dans la catégorie concernée. De plus, même dans ce cas, toute décision du Conseil d’Ad-
ministration prise pendant la période transitoire devrait être ratifiée par les actionnaires.

La Société sera engagée, en toutes circonstances (y compris dans le cadre de la gestion journalière), vis-à-vis des tiers

(i) par la signature d’un administrateur unique en présence d’un administrateur unique, ou (ii) la signature conjointe d’un
administrateur A et d’un administrateur B, ou (ii) par la signature individuelle du délégué à la gestion journalière, ou (iii)
par les signatures conjointes de toutes personnes ou l’unique signature de toute personne à qui de tels pouvoirs de
signature auront été délégués par le Conseil d'Administration, et ce, dans les limites des pouvoirs qui leur auront été
conférés.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués

à neuf cents euros (900,-EUR).

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance a été levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connu du notaire instrumentant, par ses nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec, le notaire instrumentant, le présent acte.

Signé: V. PIERRU, C. DOSTERT, J.M. RAMIREZ RODRIGUEZ, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 25 novembre 2014. LAC/2014/55559. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 16 décembre 2014.

Référence de publication: 2014201201/115.
(140224597) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2014.

Danube Bidco S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 139.927.

<i>Extrait de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du 12 décembre 2014

L'assemblée a accepté la démission de tous les administrateurs de la société en date du 12 décembre 2014, à savoir:
- Mr. Emmanuel Floret démissionne de son poste d'administrateur de catégorie A1;
- Mr. Graham Hislop démissionne de son poste d'administrateur de catégorie A2;
- Mr. Patrick Van Denzen démissionne de son poste d'administrateur de catégorie B1;
- Mr. Franciscus Welman démissionne de son poste d'administrateur de catégorie B1;
- Mme. Betty Prudhomme démissionne de son poste d'administrateur de catégorie B2;
- Melle Fantine Jeannon démissionne de son poste d'administrateur de catégorie B2;
Par ailleurs, l'assemblée a décidé de nommer en date du 12 décembre 2014:
- Melle Fantine Jeannon, née le 8 novembre 1986 à Nancy (France), ayant son adresse professionnelle au 412F, route

d'Esch, L-2086 Luxembourg;

- Mr. Diogo Alves, né le 14 mars 1986 à Macieira de Cambra (Portugal), ayant son adresse professionnelle au 412F,

route d'Esch, L-2086 Luxembourg;

- Mr. Chokri Bouzidi, né le 10 may 1964 à Bousalem (Tunisie), ayant son adresse professionnelle au 2, rue Jean Monnet,

L-2180 Luxembourg;

- Mr. Ben Burton, né le 29 mars 1980 à Jersey (Jersey), ayant son adresse professionnelle au 2830 The Parade, JE1 1ZZ

St Helier, Jersey, Îles anglo-normandes;

- Mr. David Hazzard, né le 5 octobre 1966 à Leeds (Royaume-Uni), ayant son adresse professionnelle au 28-30 The

Parade, JE1 1ZZ St Helier, Jersey, Îles anglo-normandes;

- Mr. Andrew Le Gal, né le 17 novembre 1976 à Jersey (Jersey), ayant son adresse professionnelle au 28-30 The Parade,

JE1 1ZZ St Helier, Jersey, Îles anglo-normandes;

en tant que nouveaux administrateurs de la société et ce, pour une période de 5 ans.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014200015/30.
(140223742) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2014.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

3648


Document Outline

Adelca Invest

Appleton S.à r.l.

ARISTEA SICAV

ATMAN SICAV

ATMAN SICAV

Banque Degroof Luxembourg S.A.

Belmilk S.A.

Bluebird Securities S.A.

CARRON S.A., société de gestion de patrimoine familial

C &amp; I Holdings S.à r.l.

Cosbet Lux S.A.

Danube Bidco S.A.

DZBP II

European Responsible Fund

Europe Logistics Venture 1

Extreme Growth Fund SICAV-SIF

Ganador

Garganey Sàrl

Haus + Technik s.àr.l.

Merym S.A.

Nascent Group S.A.

Nobileo S.à r.l.

OCM Luxembourg POF IV A S.à r.l.

Office Lease Invest S.A.

Palladio S.A.

Petercam L Fund

Procom-Immobilière S.A.

ProLogis European Properties Fund II

Prologis Targeted Europe Logistics Fund

Pro-Vision SD S.A.

Pro-Vision SD S.à r.l.

Pub.K Investments S.A.

Radical Euro-Services S.A.

ROLLINGER Toiture

Rollinvest S.A.

SA2M

Sairam Shipping S.A.

Salon de Coiffure Tendrelle, société à responsabilité limitée

Samor S.A.

Silinf S.A.

Silverton Properties S.à r.l.

Smart Solutions

S.V.M. S.à r.l.

Symbiotics SICAV (Lux.)

T-C Neptune Holdings S.à r.l.

Textiles Meyer S.à r.l.

Tishman Speyer Lumiere Holdings I S.à r.l.

UBM CP Holdings No 4 S.à.r.l

Uewen &amp; Feier

Zamataimmo S.A.

Zermatt S.A.

ZIA S.A., société de gestion de patrimoine familial