logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 3912

17 décembre 2014

SOMMAIRE

3B4Sports S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

187776

C2B Group S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

187738

Capital Européen S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

187731

Captalents Development S.A.  . . . . . . . . . . .

187732

Captalents Development S.A.  . . . . . . . . . . .

187732

Carnet S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

187732

Carnet S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

187732

CB Lux S.à r.l.-FIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

187733

Celebrating  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

187733

CF Consulting S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

187733

Chamaeleon S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

187734

Chamaeleon S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

187734

CHH France 1 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

187734

CII, Luxembourg Branch . . . . . . . . . . . . . . . .

187736

Cilix Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

187734

CKYAD. M. Transport  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

187735

Clairam S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

187735

Colors Capital Companies  . . . . . . . . . . . . . .

187735

Compagnie d'Investissement du Sud S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

187735

Compagnie Financière Terria S.A. . . . . . . .

187736

Compas S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

187736

Comptabilité Thill Susi Sàrl  . . . . . . . . . . . . .

187736

Craven Properties S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

187737

CRF2T S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

187737

CT Real Estate  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

187737

Cuni-Fuels S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

187738

Dazzle Luxembourg N° 2 S.A. . . . . . . . . . . .

187745

Dazzle Luxembourg N° 3 S.A. . . . . . . . . . . .

187746

DB Vita  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

187749

Defoe Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

187746

Delling Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

187749

Demaison S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

187749

Demsec S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

187749

Deutsche Zinshaus Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . .

187748

Dream Global 26 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

187748

D-R Luxembourg Holding 1  . . . . . . . . . . . . .

187740

Food Delivery Holding 5 S.à r.l. . . . . . . . . . .

187750

Revetas Holding LX 1 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

187776

SRE Waterloo Holding Sàrl  . . . . . . . . . . . . .

187774

St August Lux Intermediate Holdco S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

187761

VCP VII Luxco 6 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

187730

Ventura Investors S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

187730

Vicaro S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

187730

Vittoria Sport  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

187731

Voltana Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

187730

187729

L

U X E M B O U R G

VCP VII Luxco 6 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 149.734.048,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 156.876.

Am 23. Juli 2014 beschlossen die Aktionäre die Abschlussprüfer PricewaterhouseCoopers, Société cooperative, mit

Sitz in 400 route d'Esch, L-1471 Luxembourg für das Geschaeftsjahr 2014 wieder zu berufen fuer einen Zeitraum bis zu
der ordentlichen Hauptversammlung, die im Jahr 2015 stattfinden wird.

Luxembourg, den 2. Dezember 2014.

Référence de publication: 2014192217/12.
(140214036) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

Voltana Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 163.345.

Le Bilan et l’affectation du résultat au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 décembre 2014.

Référence de publication: 2014192215/11.
(140213965) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

Ventura Investors S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 105.791.

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Un administrateur

Référence de publication: 2014192218/11.
(140214193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

Vicaro S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9147 Erpeldange, 2, rue Sébastien Conzémius.

R.C.S. Luxembourg B 93.101.

<i>Auszug aus dem Protokoll der Versammlung des Verwaltungsrates vom 6. November 2014

Folgendes wurde einstimmig beschlossen:

<i>Erster und einziger Beschluss

Der Verwaltungsrat beschließt, mit sofortiger Wirkung, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen

Rechts, FIDUNORD S.à r.l., mit Sitz in L - 9991 Weiswampach, 61, Gruuss-Strooss, eingetragen im luxemburgischen
Handels- und Firmenregister, unter der Nummer B 91.906, zum Depositar der Inhaberaktien der Gesellschaft zu ernen-
nen, gemäß Artikel 2 und folgenden des Gesetzes vom 28. Juli 2014 betreffend die Immobilisierung der Inhaberaktien und
-anteile, sowie das Führen eines Inhaberaktienregisters.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, den 2. Dezember 2014.

<i>Für VICARO S.A.
FIDUNORD S.à r.l.

Référence de publication: 2014192221/19.
(140213641) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

187730

L

U X E M B O U R G

Vittoria Sport, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 192.283.

L'an deux mille quatorze, le vingt-huit novembre.
Par-devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

Madame Virginie PIERRU, clerc de notaire, demeurant professionnellement à L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling,

agissant en sa qualité de mandataire pour:

1. Madame Karine SERNAGLIA, Cadre territoriale, née le 13 juin 1966 à Clamart (France), demeurant au 5, rue Nicolas

GUYE F-88100 Saint Dié des Vosges (France),

2. Monsieur Silvio MARTINUZZI, chef d'entreprises, né le 19 avril 1969 à Saint-Dié (France), demeurant au 5, rue

Nicolas GUYE F-88100 Saint Dié des Vosges (France), et

3. Monsieur Umberto MARTINUZZI, Directeur commercial, né le 13 avril 1965 à Saint-Dié (France), demeurant au

114bis, Rue du Maréchal Galliéni à F-77400 Thorigny sur Marne (France),

en vertu de trois (3) procurations données sous seing privé.
Lesquelles procurations resteront annexées aux présentes pour les besoins de l'enregistrement, après avoir été pa-

raphées «ne varietur» par la mandataire et le notaire instrumentant, pour les besoins de l'enregistrement.

Les comparants, représentés comme ci-avant, sont les seuls et uniques associés (les «Associés») de «VITTORIA S.à

r.l.» (la «Société») établie et ayant son siège social au 8, Boulevard de la Foire L-1528 Luxembourg, non encore déposé
au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.

Les comparants, représentés comme ci-avant, ont exposé au notaire instrumentant ce qui suit:
En date du 3 octobre 2014, le notaire instrumentant a reçu sous le numéro 2375 de son répertoire, un acte de

constitution d'une société à responsabilité limitée («l'Acte») «VITTORIA S.à r.l.» (la «Société») établie et ayant son siège
social au 8, Boulevard de la Foire L-1528 Luxembourg, enregistré à Luxembourg en date du 9 octobre 2014, relation
LAC/2014/47030, non encore déposé au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.

Or les comparants, représentés comme ci-avant, déclarent par les présentes que la dénomination sociale de la Société

choisie en date du 3 octobre 214 n'est plus disponible, ils requièrent, par la présente la rectification dans le premier article
des statuts de la Société dans l'Acte comme suit:

«  Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous le nom de «VITTORIA SPORT» (ci-

après la «Société») qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales telle que modifiée ainsi que par les présents statuts.»

Les effets du présent acte débutent le 3 octobre 2014.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunération et charges qui incombent à la Société en raison du présent acte, sont évalués à cinq

cents euros (500,- EUR).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparants, connue par le notaire instrumentaire

par nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: V. PIERRU, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 1 

er

 décembre 2014. LAC/2014/56699. Reçu douze euros 12,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 02 décembre 2014.

Référence de publication: 2014192226/47.
(140213971) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

Capital Européen S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 114.012.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 mit allen dazugehörigen Unterlagen wurde beim Handels- und Gesell-

schaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

187731

L

U X E M B O U R G

CAPITAL EUROPEEN S.A.

Référence de publication: 2014192388/11.
(140214336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2014.

Captalents Development S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 16A, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 142.045.

Les comptes annuels clos au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014192389/10.
(140214666) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2014.

Captalents Development S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 16A, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 142.045.

<i>Extrait de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 2 décembre 2014

Révocation d'un administrateur et nomination d'un nouvel administrateur
L'assemblée générale décide de révoquer avec effet au 19 novembre 2014, Monsieur Dominique DELABY en sa qualité

d'administrateur et nomme avec effet au 19 novembre 2014 aux fonctions d'administrateur, pour une durée prenant fin
lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2019:

- Paul AGNES
Né le 25/08/1941 à Ettelbrück (Luxembourg)
Demeurant professionnellement à L-1930 Luxembourg, 16a avenue de la Liberté
Reconduction des mandats des administrateurs et du commissaire
L'assemblée générale décide de reconduire le mandat des administrateurs, Monsieur François DEKEYSER et Madame

Marie-Pierre VANDEPUTTE ainsi que du commissaire aux comptes, la société VERICOM S.A. pour une durée prenant
fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2019.

Modification de l'adresse du commissaire aux comptes
VERICOM SA
R.C.S. Luxembourg n° 51203
avec siège social à L-2341 Luxembourg, 1, rue du Plébiscite
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014192390/24.
(140214690) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2014.

Carnet S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1430 Luxembourg, 22, boulevard Pierre Dupong.

R.C.S. Luxembourg B 53.507.

Les comptes au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

CARNET S.A.

Référence de publication: 2014192391/10.
(140214852) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2014.

Carnet S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1430 Luxembourg, 22, boulevard Pierre Dupong.

R.C.S. Luxembourg B 53.507.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 02

<i>décembre 2014

Monsieur ROSSI Jacopo et Monsieur DONATI Régis sont renommés administrateurs pour une nouvelle période de

trois ans. Monsieur DE BERNARDI Alexis est renommé commissaire aux comptes pour la même période.

187732

L

U X E M B O U R G

Monsieur GALIONE Gioacchino, expert comptable, né le 04.01.1982 à LA LOUVIERE (Belgique), adresse profession-

nelle au 17 rue Beaumont, L - 1219 Luxembourg (Luxembourg), est nommé nouvel administrateur en remplacement de
Monsieur WEIDIG Paul pour une période de trois ans.

Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2017.

Pour extrait sincère et conforme
CARNET S.A.
Jacopo ROSSI / Régis DONATI
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2014192392/19.
(140214932) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2014.

CB Lux S.à r.l.-FIS, Société à responsabilité limitée sous la forme d'une SICAF - Fonds d'Investissement

Spécialisé.

Capital social: EUR 74.646.553,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 108.295.

EXTRAIT

Monsieur Claude Berda, gérant unique de la Société, a changé d'adresse, il réside à présent au 116-118, avenue des

Statutaires, B-1180 Bruxelles, Belgique.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 2 décembre 2014.

Pour extrait conforme
ATOZ SA
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Signature

Référence de publication: 2014192393/20.
(140214376) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2014.

Celebrating, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6231 Bech, 20A, Neidiierfchen.

R.C.S. Luxembourg B 168.194.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour le gérant

Référence de publication: 2014192394/10.
(140214885) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2014.

CF Consulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 46, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 175.913.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 décembre 2014.

Référence de publication: 2014192395/10.
(140214470) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2014.

187733

L

U X E M B O U R G

Chamaeleon S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5433 Niederdonven, 8, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 124.525.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014192397/10.
(140214397) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2014.

Chamaeleon S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5433 Niederdonven, 8, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 124.525.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014192398/10.
(140214399) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2014.

CHH France 1 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 192.154.

- Constituée suivant acte reçu par Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 10

novembre 2014.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société qui s'est tenue le 11 novembre 2014

à Luxembourg, que les décisions suivantes ont été prises à l'unanimité des voix:

-  démission  de  Monsieur  Felix  FABER,  employé  privé,  demeurant  professionnellement  à  L-2450  Luxembourg,  15,

boulevard Roosevelt; administrateur de catégorie A;

- nomination de H.E. Sheikh Hamad bin Jassim bin Jabr AL-THANI, demeurant professionnellement à Al Wajba Palace,

Dukhan Road - DOHA - QATAR: administrateur de catégorie A;

- nomination de H.E. Sheikh Jassim bin Hamad bin Jassim bin Jabr AL-THANI, demeurant professionnellement à Al

Wajba Palace, Dukhan Road - DOHA - QATAR: administrateur de catégorie A;

- nomination de Monsieur Felix FABER, employé privé, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15,

boulevard Roosevelt; administrateur de catégorie B.

Tous ces mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2020.

<i>Pour la société CHH France 1 S.A.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Référence de publication: 2014192399/22.
(140214670) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2014.

Cilix Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 166.103.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société tenue en date du 21 novembre

<i>2014 à 09.00 heures au siège social de la société

<i>Résolutions

Après délibération, les résolutions suivantes sont successivement mises au vote:

<i>Première résolution

Le siège social de la société est transféré ce jour à l'adresse suivante:
370, route de Longwy
L-1940 Luxembourg
Cette résolution est adoptée à l'unanimité

187734

L

U X E M B O U R G

<i>Deuxième résolution

La démission de l'administrateur Monsieur Mc GAW Didier est acceptée avec effet immédiat
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

<i>Troisième résolution

Madame CARDOSO Isabelle, née le 27/02/1977 et demeurant professionnellement au 370, route de Longwy, L-1940

Luxembourg est nommé administrateurs jusqu'à l'assemblée générale qui aura lieu en 2017:

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Référence de publication: 2014192402/23.
(140214741) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2014.

CKYAD. M. Transport, Société en Commandite simple.

Siège social: L-8813 Bigoonville, 14, rue du Village.

R.C.S. Luxembourg B 191.580.

En son Assemblée Générale Extraordinaire du 1 

er

 Décembre tenue au 14 rue du village à Bigonville à l'unanimité des

vois, l'Assemblée acceptée:

1. Monsieur KUYKA KUL MOUTHOMBO né le 02 janvier 1968 à Kinshasa R.D Congo, domicilié à 12 52146 Würselen

est nommé Gérant Technique en outre il est chargé de la gestion de la société, et ce à partir de ce jour.

2. Madame YOHANNE WAKASSA MUSHIYA MANUELLA née le 25 Août 1987 à Kinshasa R.D Congo, domiciliée à

Morlaixplatz 12 52146 Würselen est nommé est Gérant Administratif.

Pour extrait conforme
KYUKA KUL MOUTHOMBO
<i>Gérant

Référence de publication: 2014192403/16.
(140215109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2014.

Clairam S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 69.720.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014192404/10.
(140214345) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2014.

Colors Capital Companies, Société Anonyme.

Capital social: EUR 169.168,80.

Siège social: L-5376 Übersyren, 35, rue de Beyren.

R.C.S. Luxembourg B 169.052.

Les statuts coordonnés au 20 novembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014192405/10.
(140214276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2014.

Compagnie d'Investissement du Sud S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1148 Luxembourg, 12, rue Jean l'Aveugle.

R.C.S. Luxembourg B 157.000.

Les résolutions suivantes ont été prises par l'actionnariat de la Société en date du 10 octobre 2014:
- II est décidé d'accepter avec effet au 30 septembre 2014 la démission de Madame Jessica Schaedler, née le 31 mars

1982, demeurant professionnellement au 41 avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg).

187735

L

U X E M B O U R G

- II est décidé d'accepter avec effet au 30 septembre 2014 la démission de Monsieur Nicolas Brau, né le 7 novembre

1959 à Genève (Suisse), demeurant professionnellement au 10 Marina Boulevard, MBFC building, Tower 2, #16-01 floor,
SGP - 018983 Singapore.

- II est décidé de nommer Monsieur Karim Reziouk, né à Hayange (France), le 5 février 1975, demeurant profession-

nellement au 41 avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg) au poste d'administrateur,
avec effet au 1 

er

 octobre 2014 et jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2020.

Pour extrait
<i>Pour la société

Référence de publication: 2014192406/18.
(140214324) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2014.

Compagnie Financière Terria S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 46.567.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014192407/10.
(140214311) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2014.

Compas S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 114.428.

Le Bilan et l’affectation du résultat au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 Novembre 2014.

Compas S.A.
Nathalie S.E. Chevalier
<i>Directeur B

Référence de publication: 2014192408/14.
(140214842) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2014.

Comptabilité Thill Susi Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4622 Differdange, 24, rue Pierre Martin.

R.C.S. Luxembourg B 96.642.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014192409/10.
(140214637) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2014.

CII, Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-2450 Luxembourg, 10-12, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 163.285.

<i>Extrait des résolutions du président de CPPIB Credit Investment Inc. datées du 1 

<i>er

<i> décembre 2014

Le président de CPPIB Credit Investment Inc. a pris acte de la démission de Olivier Dorier en tant que représentant

permanent de la Succursale avec effet au 1 

er

 décembre 2014 et a décidé de nommer Jean-Christophe Gladek dont

l'adresse professionnelle se situe au 10-12, boulevard Roosevelt, L-2450 Luxembourg avec effet au 1 

er

 décembre 2014

et pour une durée indéterminée.

Le représentant permanent est investi de tout pouvoir, agissant sous sa seule signature, pour signer tout document,

agir, représenter et engager la Succursale afin de réaliser l'objet de la Succursale tel que décrit dans l'objet de la succursale

187736

L

U X E M B O U R G

et de tous autres pouvoirs nécessaires ou utiles à la gestion de la Succursale. En outre, le représentant permanent possède
un pouvoir de signature bancaire au nom de la Succursale.

Le président de CPPIB Credit Investment Inc. a décidé de transférer le siège social de la Succursale au 10-12, boulevard

Roosevelt, L-2450 Luxembourg avec effet au 1 

er

 décembre 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour CII, Luxembourg Branch
Un Mandataire

Référence de publication: 2014192410/21.
(140214464) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2014.

Craven Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 124.797.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014192411/10.
(140214416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2014.

CRF2T S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 186.679.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 12 novembre 2014

L'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- Nomination de Monsieur Csaba Horvath, né le 30 septembre 1980, à Tatabànya, Hongrie, demeurant profession-

nellement au 23, rue Aldringen L-1118 Luxembourg en qualité de gérant de la Société avec effet au 17 novembre 2014
et pour une durée illimitée (en remplacement de Monsieur Karl Heinz Horrer, démissionnaire).

Le conseil de gérance de la Société se compose dorénavant comme suit:
- M. Stefan Holmér;
- M. Csaba Horvath;
- M. Richard Browne et
- M. Luc de Vet.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 novembre 2014.

<i>Pour CRF2T S.à r.l.
Citco Fund Services (Luxembourg) S.A.
Signatures
<i>Mandataire

Référence de publication: 2014192414/24.
(140214982) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2014.

CT Real Estate, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 171.164.

<i>Extrait des résolutions prises par le Gérant Unique en date du 2 Décembre 2014

Il résulte de la résolution du gérant unique datée du 2 décembre 2014 que:
- Le siège social de la société CT REAL ESTATE est transféré de son adresse actuelle 22, rue Marie-Adélaïde, L-2128

Luxembourg au 62, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, et ceci avec effet au 1 

er

 décembre 2014.

187737

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 2 décembre 2014.

Certifié sincère et conforme
Eric STAEL
<i>Gérant Unique

Référence de publication: 2014192415/16.
(140214789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2014.

Cuni-Fuels S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9012 Ettelbruck, 39, avenue des Alliés.

R.C.S. Luxembourg B 92.263.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 3 novembre 2014 à 11.30 heures au siège social de la

<i>société

L'assemblée a décidé de nommer en tant qu'administrateur supplémentaire la personne suivante:
- Madame Julia MEYER, née le 27/04/1985 à Saint-Vith (B) et demeurant B-4782 Schönberg, Zum Burren 17.
Cette nomination prend effet à partir de ce jour et jusqu'à l'assemblée générale 2015 statuant sur les comptes annuels

de l'exercice 2014.

Ainsi, le nombre des administrateurs passe de 3 à 4 membres.

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un administrateur

Référence de publication: 2014192416/17.
(140214882) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2014.

C2B Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1311 Luxembourg, 22, boulevard Marcel Cahen.

R.C.S. Luxembourg B 192.322.

STATUTS

L'an deux mille quatorze, le vingt-huit novembre
Par-devant Maître Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains.

Ont comparu:

1. Monsieur Nicolas Bendjebbar exerçant la profession de «Commercial Grands Comptes» et demeurant au 48 Avenue

du Général de Gaulle F-77600, Bussy Saint-Georges (France)

2. Monsieur Rachid Boussetta, exerçant la profession de «Chargé d’Affaires» et demeurant au 34 Avenue de la société

des nations F-77144, Montévrain (France)

3. Monsieur Farid Chatar, exerçant la profession de «Consultant Fiscal» et demeurant au 22 Boulevard Marcel Cahen

L-1311, Luxembourg (Luxembourg)

4. Monsieur Romain David Cordier, exerçant la profession de «Consultant Fiscal» et demeurant au 32a Rue Henri

Lamormesnil L-1915, Luxembourg (Luxembourg)

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à respon-

sabilité limitée qu'ils déclarent constituer entre eux:

Titre I 

er

 . Dénomination - Siège social - Objet - Durée - Capital social

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui

pourront le devenir par la suite une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois qui sera régie par les lois y
relatives ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet l’achat et la vente de matériels et de matériaux de construction à destination des

professionnels et des particuliers ainsi que tous autres services y relatifs. En outre, la société pourra exercer toute autre
activité commerciale à moins qu'elle ne soit spécialement réglementée. D’une façon générale, elle pourra faire toutes les
opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement à son objet social ou qui
seraient de nature à en faciliter ou développer la réalisation.

Art. 3. La société prend la dénomination de C2B Group S.à r.l..

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.

187738

L

U X E M B O U R G

Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés. La

société peut ouvrir des agences ou des succursales dans toutes les autres localités du pays et à l’étranger.

Art. 5. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de 12.500 Euros (douze mille cinq cents euros), représenté par 500 (cinq

cents) parts sociales d'une valeur nominale de 25 Euros (vingt-cinq euros) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle du nombre des parts existantes dans l’actif

social et dans les bénéfices.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées à des non-associés

qu'avec l’agrément donné en assemblée des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Titre II. Administration - Assemblée Générale

Art. 9. La société est administrée et gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, salariés ou gratuits, nommés

par l’assemblée des associés, qui fixe leurs pouvoirs. Ils peuvent à tout moment être révoqués par l’assemblée des associés.

A moins que les associés n'en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom

de la société en toutes circonstances.

En tant que simple mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction aucune

obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; ils ne seront
responsables que de l’exécution de leur mandat.

La Société est valablement engagée, en toutes circonstances, par la signature du gérant unique ou, en cas de pluralité

de gérants, par la signature conjointe de deux gérants ou par la (les) autre(s) signature(s) de toute(s) autre(s) personne
(s) à laquelle (auxquelles) pareil pouvoir de signature aura été délégué par le gérant unique ou par les gérants.

Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts lui appartenant.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente; chaque associé peut se

faire représenter valablement aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles aient été adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux présents statuts doivent être prises à la majorité des

associés représentant les trois quarts du capital social.

Titre III. Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 12. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 13. Chaque année, à la clôture de l’exercice, les comptes de la société sont arrêtés et la gérance dresse les comptes

sociaux, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Art. 14. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 15. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugées

nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition des associés.

Titre IV. Dissolution - Liquidation

Art. 16. La société n'est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

Art. 17. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer

des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilans et inventaires de la société.

Art. 18. En cas de dissolution de la société, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés, qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Disposition générale

Art. 19. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions légales en vigueur régissant les sociétés à responsabilité limitée.

<i>Souscription et libération

Les cinq cents (500) parts sociales sont souscrites comme suit:

1) par Monsieur Nicolas Bendjebbar, préqualifié, cent vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

187739

L

U X E M B O U R G

2) par Monsieur Rachid Boussetta, préqualifié, cent vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
3) par Monsieur Farid Chatar, préqualifié, cent vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
4) par Monsieur Romain David Cordier, préqualifié, cent vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de

douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a
été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2014.

<i>Assemblée générale extraordinaire.

Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et

ont pris à l’unanimité des voix les décisions suivantes:

1. Sont nommés gérants pour une durée illimitée:
- Monsieur Nicolas Bendjebbar exerçant la profession de «Commercial Grands Comptes» et demeurant au 48 Avenue

du Général de Gaulle F-77600, Bussy Saint-Georges (France);

- Monsieur Rachid Boussetta, exerçant la profession de «Chargé d’Affaires» et demeurant au 34 Avenue de la société

des nations F-77144, Montévrain (France);

- Monsieur Farid Chatar, exerçant la profession de «Consultant Fiscal» et demeurant au 22 Boulevard Marcel Cahen

L-1311, Luxembourg (Luxembourg);

- Monsieur Romain David Cordier, exerçant la profession de «Consultant Fiscal» et demeurant au 32a Rue Henri

Lamormesnil L-1915, Luxembourg (Luxembourg).

2. Le siège social est fixé au 22, boulevard Marcel Cahen à L-1311 Luxembourg.

<i>Avertissement

Le notaire a attiré l’attention des comparants, agissant dans les qualités telles que précisées ci-dessus, que la Société

doit obtenir une autorisation d'établissement de la part des autorités administratives compétentes en rapport avec son
objet social avant de commencer son activité commerciale, avertissement que les comparants reconnaissent avoir reçu.

<i>Évaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ mille quatre cents euros (EUR
1.400).

Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l’étude du notaire soussigné, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: N. Bendjebbar, R. Boussetta, F. Chatar, R.D. Cordier, M. Loesch.
Enregistré à Remich, le 1 

er

 décembre 2014. REM/2014/2616. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

Pour expédition conforme.

Mondorf-les-Bains, le 3 décembre 2014.

Référence de publication: 2014192418/119.
(140214887) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2014.

D-R Luxembourg Holding 1, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 18.399,00.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 147.207.

In the year two thousand and fourteen, on the third day of November.
Before Maître Francis Kesseler, notary public established in Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

D-R Luxembourg Holding 3 S.à r.l., a private limited liability company (“société à responsabilité limitée”) organized

under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 8-10, Avenue de la Gare, L-1610
Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 183.322 (the “Sole
Shareholder”),

187740

L

U X E M B O U R G

hereby represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, notary clerk, with professional address at 5, rue Zénon

Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, by virtue of a proxy given under private seal.

Such proxy having been signed “ne varietur” by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, shall remain attached to this deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record as follows:
I.- The appearing party is the sole shareholder of D-R Luxembourg Holding 1, a private limited liability company

(“société à responsabilité limitée”) organized under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered
office at 8-10, Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, incorporated by a deed enacted by Maître Elvinger, notary residing
in Luxembourg, on 10 July 2009, published in the “Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations” number 1546 dated
11 August 2009, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 147.207 (the
“Company”).

II.- The 15,989 (fifteen thousand nine hundred eighty-nine) shares, with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each,

representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the
items of the agenda of which the Sole Shareholder expressly states having been duly informed beforehand.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1. Waiving of notice right;
2. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 2,410 (two thousand four hundred ten Euro) so

as to raise it from its current amount of EUR 15,989 (fifteen thousand nine hundred eighty-nine Euro) to EUR 18,399
(eighteen thousand three hundred ninety-nine Euro) by the issue of 2,410 (two thousand four hundred ten) shares with
a nominal value of EUR 1 (one Euro) each, subject to the payment of a global share premium amounting to EUR 9,997,590
(nine million nine hundred ninety-seven thousand five hundred ninety Euro), such share premium shall be attached to the
new shares issued under this increase of share capital and be exclusively reserved to the benefit of the holder of such
shares, the whole to be fully paid up through a contribution in kind;

3. Subscription and payment by Dresser-Rand Group Inc. of the new shares by way of a contribution in kind;
4. New composition of the shareholding of the Company;
5. Subsequent amendment to article 6 of the articles of association of the Company; and
6. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolutions have been taken:

<i>First resolution:

The Sole Shareholder resolves to waive its right to the prior notice of the current meeting; the Sole Shareholder

acknowledges being sufficiently informed on the agenda and considers the meeting to be validly convened and therefore
agrees to deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is further resolved that all the relevant documentation
has been put at the disposal of the Sole Shareholder within a sufficient period of time in order to allow it to examine
carefully each document.

<i>Second resolution:

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 2,410 (two thousand

four hundred ten Euro), so as to raise it from its current amount of EUR 15,989 (fifteen thousand nine hundred eighty-
nine Euro) to EUR 18,399 (eighteen thousand three hundred ninety-nine Euro) by the issuance of 2,410 (two thousand
four hundred ten) new shares with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each (the “New Shares”), subject to the payment
of a global share premium amounting to EUR 9,997,590 (nine million nine hundred ninety-seven thousand five hundred
ninety Euro) (the “Share Premium”), such share premium shall be attached to the new shares issued under this increase
of share capital and be exclusively reserved to the benefit of the holder of such shares, the whole to be fully paid by a
contribution  in  kind  made  by  Dresser-Rand  Group  Inc.,  a  public  company  organized  under  the  laws  of  the  State  of
Delaware, United States of America, having its registered office at 1209, Orange Street, Wilmington, Delaware 19801,
United States of America and registered with the Delaware Secretary of State under number 3861720 (the "Contributor").

For the avoidance of doubt, any share premium previously paid on shares is attached to such shares issued by the

Company and exclusively reserved to the benefit of the holder of such shares.

<i>Third resolution:

The Sole Shareholder further resolves to accept the subscription and the payment by the Contributor of the New

Shares and the Share Premium through the contribution in kind as detailed below.

<i>Intervention - Subscription - Payment

Thereupon intervenes the Contributor, hereby represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, by virtue of a proxy

given under private seal and declares to subscribe to the New Shares.

187741

L

U X E M B O U R G

The issue of the New Shares is also subject to the payment of the Share Premium. The New Shares and the Share

Premium have been fully paid-up by the Contributor through a contribution in kind as described below.

<i>Description of the contribution

The contribution made by the Contributor, in exchange for the issuance of the New Shares and the payment of the

Share Premium, is composed of a certain receivable held by the Contributor (the “Contribution”).

<i>Valuation

The net value of the Contribution amounts to EUR 10,000,000 (ten million Euro).
Such valuation has been approved by the managers of the Company pursuant to a statement of contribution value

dated November 3 

rd

 , 2014, which shall remain annexed to this deed to be submitted with it to the formality of regis-

tration.

<i>Evidence of the Contribution’s existence

A proof of the existence of the Contribution has been given to the Company.

<i>Managers’ intervention

Thereupon intervene:
a) Mr. Aidan Foley, residing professionally at 8-10, Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, category A manager of

the Company;

b) Mr. Tamas Horvath, residing professionally at 8-10, Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, category A manager

of the Company;

c) Mr. Raymond L. Carney Jr., residing professionally at 10205 Westheimer Road, Houston, TX, 77042 United States

of America, category B manager of the Company; and

d) Mr. Robert J. Saltarelli, residing professionally at 10205, Westheimer Road, Houston, TX, 77042 United States of

America, category B manager of the Company;

all represented here by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, prenamed, in accordance with the provisions of the sta-

tement of contribution value.

Acknowledging having been previously informed of the extent of their responsibility, legally bound as managers of the

Company by reason of the Contribution, expressly agree with the description of this Contribution, with its valuation,
and confirm the validity of the subscription and payment.

<i>Fourth resolution:

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the shareholding of the Company is now composed as

follows:

- D-R Luxembourg Holding 3 S.à r.l.: 15,989 (fifteen thousand nine hundred ninety-nine) shares; and
- Dresser-Rand Group Inc.: 2,410 (two thousand four hundred ten) shares.
The notary acts that the 18,399 (eighteen thousand three hundred ninety-nine) shares, representing the entire share

capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on the resolution to be taken below.

<i>Fifth resolution:

As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the Contribution having been fully carried out, it

is resolved to amend articles 6.1 and 6.2 of the articles of association of the Company so as to read as follows:

Art. 6.1. Subscribed and paid-up share capital. The Company's share capital is fixed at EUR 18,399.- (eighteen thousand

three hundred ninety-nine Euro) represented by 18,399 (eighteen thousand three hundred ninety-nine) shares (parts
sociales) (hereafter, the "Shares") with nominal value of 1.- Euro (one Euro) each, all fully subscribed and entirely paid-
up.

At the moment and as long as all the Shares are held by only one shareholder, the Company is a one-member company

(société unipersonnelle) in the meaning of article 179 (2) of the Law. In this contingency articles 200-1 and 200-2 of the
Law, among others, will apply, this entailing that each decision of the sole shareholder and each contract concluded
between him and the Company represented by him shall have to be established in writing.

6.2. Modification of share capital. The share capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder

or by decision of the general shareholders' meeting, in accordance with article 9 of these Articles and within the limits
provided for by article 199 of the Law.

Any share premium paid on shares shall be attached to such shares and be exclusively reserved to the benefit of the

holder of such shares."

No other amendments shall be made to this article.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

187742

L

U X E M B O U R G

Whereof  the  present  notarial  deed  was  drawn  up  in  Esch-sur-Alzette  on  the  day  named  at  the  beginning  of  this

document.

The document having been read to the person appearing, it signed together with us, the notary, the present original

deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le troisième jour du mois de novembre.
Par devant Maître Francis Kesseler, notaire public établi à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

D-R Luxembourg Holding 3 S.à r.l., une société à responsabilité limitée organisée selon les lois du Grand-Duché de

Luxembourg, ayant son siège social sis au 8-10, Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 183.322 (l’«Associé Unique»),

ici dûment représentée par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, clerc de notaire, avec adresse professionnelle sise au

5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et

le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci auprès des autorités de
l’enregistrement.

La partie comparante, représentée tel que décrit ci-dessus, a requis du notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. La partie comparante est l’associé unique de D-R Luxembourg Holding 1, une société à responsabilité limitée, or-

ganisée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social sis au 8-10, Avenue de la Gare, L-1610
Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Elvinger, notaire résidant à Luxembourg, le 10 juillet 2009, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1546 daté du 11 août 2009, et immatriculée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 147.207 (la «Société»).

II. Les 15.989 (quinze mille neuf cent quatre-vingt-neuf) parts sociales, d’une valeur nominale de 1 EUR (un Euro)

chacune, représentant la totalité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l’assemblée peut valable-
ment se prononcer sur tous les points de l’ordre du jour, dont l’Associé Unique reconnaît expressément avoir été dûment
préalablement informé.

III. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. Renonciation au droit de convocation;
2. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de 2.410 EUR (deux mille quatre cent dix Euros) afin de

le porter de son montant actuel de 15.989 EUR (quinze mille neuf cent quatre-vingt-neuf Euros) à 18.399 EUR (dix-huit
mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf Euros) par l’émission de 2.410 (deux mille quatre cent dix) parts sociales d’une
valeur nominale de 1 EUR (un Euro) chacune, moyennant le paiement d’une prime d’émission d’un montant total de
9.997.590 EUR (neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent quatre-vingt-dix Euros), cette prime d'émis-
sion  restera  attachée  aux  nouvelles  parts  sociales  émises  dans  le  cadre  de  cette  augmentation  de  capital  et  sera
exclusivement réservée au bénéfice du détenteur de ces parts sociales, le tout devant être entièrement libéré au moyen
d’un apport en nature;

3. Souscription et libération par Dresser-Rand Group Inc. des nouvelles parts sociales par voie d’apport en nature;
4. Nouvelle composition de l’actionnariat de la Société;
5. Modification subséquente de l’article 6 des statuts de la Société; et
6. Divers.
Suite à l’approbation de ce qui précède par l’Associé Unique, les résolutions suivantes ont été adoptées:

<i>Première résolution:

L’Associé Unique décide de renoncer à son droit de convocation préalable à la présente assemblée; l’Associé Unique

reconnaît avoir été suffisamment informé de l’ordre du jour et considère avoir été valablement convoqué et en consé-
quence accepte de délibérer et de voter sur tous les points portés à l’ordre du jour. Il est en outre décidé que l’ensemble
de la documentation pertinente a été mise à la disposition de l’Associé Unique dans un laps de temps suffisant afin de lui
permettre un examen attentif de chaque document.

<i>Deuxième résolution:

L’Associé Unique décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de 2.410 EUR (deux mille quatre

cent dix Euros) afin de le porter de son montant actuel de 15.989 EUR (quinze mille neuf cent quatre-vingt-neuf Euros)
à 18.399 EUR (dix-huit mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf Euros) par l’émission de 2.410 (deux mille quatre cent dix)

187743

L

U X E M B O U R G

nouvelles parts sociales d’une valeur nominale de 1 EUR (un Euro) chacune (les «Nouvelles Parts Sociales»), moyennant
le paiement d’une prime d’émission globale d’un montant de 9.997.590 EUR (neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept
mille cinq cent quatre-vingt-dix Euros) (la «Prime d’Emission»), cette prime d'émission restera attachée aux nouvelles
parts sociales  émises  dans  le cadre  de cette  augmentation  de  capital et sera exclusivement  réservée  au bénéfice  du
détenteur de ces parts sociales, le tout devant être entièrement libéré au moyen d’un apport en nature réalisé par Dresser-
Rand Group Inc., une société régie par les lois de l’Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social situé
1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801, Etats-Unis d'Amérique et enregistrée auprès du Delaware Secretary of State
sous le numéro 3861720 (l’ «Apporteur»).

Afin d'éviter toute confusion, la prime d'émission antérieurement payée sur les parts sociales restera attachée aux

parts sociales émises par la Société et exclusivement réservée au profit du détenteur de ces parts.

<i>Troisième résolution:

L’Associé Unique décide ensuite d’accepter la souscription et la libération par l’Apporteur des Nouvelles Parts Sociales

et de la Prime d’Emission au moyen de l’apport en nature tel que décrit ci-après.

<i>Intervention - Souscription - Paiement

Intervient ensuite l’Apporteur, ici représenté par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, prénommée, en vertu d’une

procuration donnée sous seing privé qui déclare souscrire les Nouvelles Parts Sociales.

L’émission des Nouvelles Parts Sociales est également sujette au paiement de la Prime d’Emission. Les Nouvelles Parts

Sociales ainsi que la Prime d’Emission ont été entièrement libérées par voie de l’apport en nature tel que décrit ci-après.

<i>Description de l’apport

L’apport réalisé par l’Associé Unique, en échange de l’émission des Nouvelles Parts Sociales et du paiement de la Prime

d’Emission, est composé d’une créance certaine détenue par l’Apporteur (l’«Apport»).

<i>Evaluation

La valeur nette de l’Apport s’élève à 10.000.000 EUR (dix millions d'Euros).
Une telle évaluation a été approuvée par les gérants de la Société conformément à une déclaration sur la valeur de

l’apport en date du 3 novembre 2014, qui restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités
d’enregistrement.

<i>Preuve de l’existence de l’Apport

Preuve de l’existence de l’Apport a été donnée à la Société.

<i>Intervention des gérants

Interviennent alors:
a) M. Aidan Foley, résidant professionnellement au 8-10, Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, gérant de catégorie

A de la Société;

b) M. Tamas Horvath, résidant professionnellement au 8-10, Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, gérant de ca-

tégorie A de la Société;

c) M. Raymond L. Carney Jr., résidant professionnellement au 10205 Westheimer Road, Houston, TX, 77042 Etats-

Unis d'Amérique, gérant de catégorie B de la Société; et

d) M. Robert J. Saltarelli, résidant professionnellement au 10205, Westheimer Road, Houston, TX, 77042 Etats-Unis

d'Amérique, gérant de catégorie B de la Société,

Tous représentés par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, prénommée, en vertu d’une procuration contenue dans la

déclaration sur la valeur de l’apport visée ci-dessus.

Reconnaissent avoir été préalablement informés de l’étendue de leur responsabilité, légalement tenus en tant que

gérants de la Société en raison de l’Apport, acceptent expressément la description de cet Apport, avec son évaluation,
et confirment la validité de la souscription et du paiement.

<i>Quatrième résolution:

En conséquence des déclarations et résolutions précédentes, l’actionnariat de la Société est désormais composé com-

me suit:

- D-R Luxembourg Holding 3 S.à r.l.: 15.989 (quinze mille neuf cent quatre-vingt-neuf) parts sociales; et
- Dresser-Rand Group Inc.: 2.410 (deux mille quatre cent dix) parts sociales.
Le notaire constate que les 18.399 (dix-huit mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf) parts sociales, représentant l’inté-

gralité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l’assemblée peut valablement décider de la résolution
à prendre ci-dessous.

187744

L

U X E M B O U R G

<i>Cinquième résolution:

En conséquence des déclarations et résolutions précédentes et l’Apport ayant été totalement réalisé, il est décidé de

modifier les articles 6.1 et 6.2 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

« 6.1. Capital souscrit et libéré. Le capital social de la Société est fixé à EUR 18.399,- (dix-huit mille trois cent quatre-

vingt-dix-neuf Euros) représenté par 18.399 (dix-huit mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf) parts sociales (ci-après "les
Parts Sociales") d'une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.

A partir du moment et aussi longtemps que toutes les Parts Sociales sont détenues par un seul associé, la Société est

une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la Loi; Dans la mesure où les articles 200-1 et 200-2 de la Loi
trouvent à s'appliquer, chaque décision de l’associé unique et chaque contrat conclu entre lui et la Société représentée
par lui sont établis par écrit.

6.2. Modification du capital social. Le capital social souscrit peut être modifié à tout moment par une décision de

l’associé unique ou par une décision de l’assemblée générale des associés conformément à l’article 9 des présents Statuts
et dans les limites prévues à l’article 199 de la Loi.

Toute prime d'émission payée sur les parts sociales restera attachée à ces parts sociales et sera réservée exclusivement

au profit du détenteur de ces parts.»

Aucune autre modification n'étant apportée à cet article.
Aucun autre point n’ayant à être traité devant l’assemblée, celle-ci a été ajournée.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur- Alzette, au jour indiqué en tête du présent document.
Lecture ayant été faite de ce document à la personne présente, elle a signé avec nous, notaire, l’original du présent

acte.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur demande de la personne présente à l’assemblée,

le présent acte est établi en anglais suivi d'une traduction française. Sur demande de la même personne et en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 05 novembre 2014. Relation: EAC/2014/14927. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2014192419/254.
(140214597) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2014.

Dazzle Luxembourg N° 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 113.835.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société tenue en date du 27 novembre

<i>2014 à 10.00 heures au siège social de la société

<i>Résolutions

Après délibération, les résolutions suivantes sont successivement mises au vote:

<i>Première résolution

Le siège social de la société est transféré ce jour à l'adresse suivante;
370, route de Longwy
L-1940 Luxembourg
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

<i>Deuxième résolution

La démission des administrateurs Monsieur LATASTE Stéphane et Monsieur Mc GAW Didier est acceptée avec effet

immédiat.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

<i>Troisième résolution

Les personnes suivantes sont nommées administrateurs jusqu'à l'assemblée générale qui aura lieu en 2017:
a) Monsieur Pierre GOFFINET, né le 15/09/1971 et demeurant professionnellement au 370, route de Longwy, L-1940

Luxembourg

187745

L

U X E M B O U R G

b) Madame CARDOSO Isabelle, née le 27/02/1977 et demeurant professionnellement au 370, route de Longwy, L-1940

Luxembourg

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Référence de publication: 2014192422/27.
(140214722) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2014.

Dazzle Luxembourg N° 3 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 114.282.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société tenue en date du 27 novembre

<i>2014 à 11.00 heures au siège social de la société

<i>Résolutions

Après délibération, les résolutions suivantes sont successivement mises au vote;

<i>Première résolution

Le siège social de la société est transféré ce jour à l'adresse suivante:
370, route de Longwy
L-1940 Luxembourg
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

<i>Deuxième résolution

La démission des administrateurs Monsieur LATASTE Stéphane et Monsieur Mc GAW Didier est acceptée avec effet

immédiat

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

<i>Troisième résolution

Les personnes suivantes sont nommées administrateurs jusqu'à l'assemblée générale qui aura lieu en 2017:
a) Monsieur Pierre GOFFINET, né le 15/09/1971 et demeurant professionnellement au 370, route de Longwy, L-1940

Luxembourg

b) Madame CARDOSO Isabelle, née le 27/02/1977 et demeurant professionnellement au 370, route de Longwy, L-1940

Luxembourg

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Référence de publication: 2014192424/27.
(140214728) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2014.

Defoe Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 24.000,00.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 182.116.

In the year two thousand fourteen, on the twenty fourth of October,
Before Maître Joseph ELVINGER, Civil Law Notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, the un-

dersigned

THERE APPEARED

JPMorgan GEOPF Luxembourg Holding S.à r.l., a Société à responsabilité limitée duly incorporated and organised under

the laws of Luxembourg with its registered office at 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxem-
bourg, registered with the Luxembourg Register of Trade and Companies under number B 127865;

duly represented by Sara Lecomte, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given

privately to her in Luxembourg on 21 October 2014 (hereinafter referred to as the Appearing Party).

The aforeseaid proxy, after signature ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary shall remain

attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The Appearing Party is the sole shareholder of Defoe Holding S.à r.l., a Société à responsabilité limitée, having its

registered office at 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, incorporated pursuant to a notarial deed enacted by the
undersigned Notary on 29 November 2013, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg
section B number 182116, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (hereinafter referred
to as the Mémorial C) number 15 dated 2 January 2014; the Articles of Association of which have been amended for the

187746

L

U X E M B O U R G

last time pursuant to a notarial deed enacted by the undersigned notary on 512 December 2013, published in the Mémorial
C number 249 on 28 January 2014.

Article 200-2 of the Luxembourg law on commercial companies of 10 August 1915, as amended (“Article 200-2”)

provides that a sole shareholder of a Société à responsabilité limitée shall exercise the powers of the general meeting of
shareholders of the Company and the decisions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.

<i>First resolution

The meeting decides the anticipated dissolution of the company and to put it into liquidation with effect as on this day.

<i>Second resolution

The meeting decides to give full and complete discharge to the managers for the performance of their mandate until

the date of the present deed.

<i>Third resolution

The general meeting decides to appoint FIDES (Luxembourg) S.A., a Société Anonyme duly established under Luxem-

bourg Laws, having its registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the Registre
de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under section B number 41469, as liquidator of the Company.

The liquidator has the broadest powers foreseen by articles 144-148 bis of the law on commercial companies. He may

execute all acts foreseen by article 145 without the authorization of the general meeting whenever it is requested. The
liquidator is dispensed to draw up an inventory and he may refer to the books of the company.

He may, under his own liability, delegate for special operations to one or more proxy holders such capacities and for

such period he may determine.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately one thousand Euro (EUR 1.000.-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the representative of the persons appearing, she signed together with us, the

notary, the present original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille quatorze, le vingt-quatre octobre,
Par devant Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

A COMPARU

JPMorgan GEOPF Luxembourg Holding S.à r.l, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son

siège social au 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés à
Luxembourg sous la section B numéro 127865, représentée par Sara Lecomte, employée privée, en vertu d'une procu-
ration  sous  seing  privé  lui-délivrée  à  Luxembourg  en  date  du  21  octobre  2014;  (ci-après  désigné  par  la  «Partie
Comparante»).

Laquelle procuration, signée ne varietur par le mandataire de la Partie Comparante et le notaire instrumentant res-

teront annexées au présent acte pour être enregistrées en même temps.

La Partie Comparante est l’Associé Unique de la Société à responsabilité limitée Defoe Holding S.à r.l., ayant son siège

social au 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés_ Luxembourg
sous la section B sous numéro 182116, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 29 novembre
2013, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (ci-après le Mémorial C) numéro 15 du 2 janvier
2014; et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivante acte reçu par le notaire soussigné en date du 12
décembre 2013 publié au Mémorial C numéro 249 du 28 janvier 2014.

<i>Première résolution

Les Associés décident de la mise en liquidation de la société avec effet immédiat.

<i>Deuxième résolution

Les Associés décident de donner décharge pleine et entière aux gérants pour l’exécution de leur mandat jusqu'à la

date des présentes.

187747

L

U X E M B O U R G

<i>Troisième résolution

Les Associés décident de nommer en tant que liquidateur, la société FIDES (Luxembourg) S.A., une société anonyme

de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, immatriculée auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 41469.

Le liquidateur prénommé a la mission de réaliser tout l’actif et apurer le passif de la société. Dans l’exercice de sa

mission, le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et il peut se référer aux écritures de la société. Le liquidateur
pourra sous sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs
à un ou plusieurs mandataires. Le liquidateur pourra engager la société en liquidation sous sa seule signature et sans
limitation. Il dispose de tous les pouvoirs tels que prévus à l’article 144 de la loi sur les sociétés commerciales, ainsi que
de tous les pouvoirs stipulés à l’article 145 de ladite loi, sans avoir besoin d’être préalablement autorisés par l’assemblée
générale des associés.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de EUR 1.000,- (mille euros).

Plus rien n'étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire des comparants, il a signé avec Nous notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: S. LECOMTE, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils le 28 octobre 2014. Relation: LAC/2014/50125. Reçu douze euros (EUR 12,-).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

Référence de publication: 2014192425/98.
(140214511) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2014.

Deutsche Zinshaus Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 161.577.

Die Bilanz zum 31. Dezember 2013 und die Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember 2013 abgelaufene

Geschäftsjahr wurden beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 3. Dezember 2014.

Deutsche Zinshaus Lux S.à r.l.
<i>Ein Bevollmächtigter

Référence de publication: 2014192426/13.
(140215116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2014.

Dream Global 26 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 9A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 189.950.

EXTRAIT

L'adresse professionnelle de M. George Valentini, gérant de catégorie A de la Société, est désormais la suivante: Suite

301, 30 Adelaide Street East, Toronto, Canada M5C 3H1.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme
Dream Global 26 S.à r.l.

Référence de publication: 2014192430/13.
(140214450) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2014.

187748

L

U X E M B O U R G

DB Vita, Société Anonyme.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 35.917.

1. ES WIRD BESCHLOSSEN, dass mit Wirkung vom 1. Oktober Herr Marcus Nagel, geschäftsansässig in Poppelsdorfer

Allee 25-33, D-53115 Bonn, vorbehaltlich der nächsten stattfindenden bestätigenden Generalversammlung der Aktionäre
der Gesellschaft, die im Jahr 2015 stattfindet und über das Geschäftsjahr 2014 entscheidet, in den Verwaltungsrat der
Gesellschaft aufgenommen wird.

2. ES WIRD FESTGESTELLT, dass sich der Verwaltungsrat demnach ab dem 1. Oktober 2014 wie folgt zusammen

setzt:

Klaus-Michael Vogel (Vorsitzender),
geschäftsansässig in 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
Dr. Boris N. Liedtke,
geschäftsansässig in 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
Ferdinand Haas,
geschäftsansässig in 178-190, Mainzer Landstrasse, D-60327 Frankfurt a. M.
Marcus Nagel,
geschäftsansässig in Poppelsdorfer Allee 25-33, D-53115 Bonn.

DB Vita
Société Anonyme

Référence de publication: 2014192442/23.
(140214393) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2014.

Delling Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 124.990.

Le Bilan et l’affectation du résultat au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 Novembre 2014.

Delling Holding S.à r.l.
Nathalie S.E. Chevalier
<i>Gérant B

Référence de publication: 2014192443/14.
(140214840) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2014.

Demaison S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6841 Machtum, 35, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 78.849.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014192444/10.
(140215112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2014.

Demsec S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 41, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 17.795.

Le bilan au 31.12.2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

187749

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 03 décembre 2014.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L-1013 Luxembourg

Référence de publication: 2014192445/14.
(140214796) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2014.

Food Delivery Holding 5 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 192.196.

STATUTES

In the year two thousand and fourteen, on the seventh day of November.
Before us Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

THERE APPEARED:

Emerging Markets Online Food Delivery Holding S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing

under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register
under number B 175.738, having its registered address at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxem-
bourg,

here represented by Mr Philippe Sylvestre, LL.M., professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in

Berlin, Germany on 1 November 2014 and in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 31 October 2014.

Said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to

this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such  appearing  party  has  requested  the  officiating  notary  to  enact  the  deed  of  incorporation  of  a  private  limited

company (société à responsabilité limitée) which it wishes to incorporate with the following articles of association:

A. Name - Purpose - Duration - Registered office

Art. 1. Name - Legal Form. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name

Food Delivery Holding 5. S.à r.l. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915
concerning commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.

Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign

companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio in view of its realisation by sale, exchange or otherwise.

2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it

holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the
Company.

2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by

issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.

2.4 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities

which it considers useful for the accomplishment of these purposes.

Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of

managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution
of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution

of the board of managers.

187750

L

U X E M B O U R G

4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances

or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
traordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwiths-
tanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

B. Share capital - Shares

Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), represented by:
5.1.1 one thousand two hundred fifty (1,250) common shares, with a nominal value of one euro (EUR 1) each (the

“Common Shares”); and

5.1.2 eleven thousand two hundred fifty (11,250) series A shares, with a nominal value of one euro (EUR 1) each (the

“Series A Shares”).

5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.3 The Company may redeem its own shares.

Art. 6. Shares.
6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of

the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.

Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection

by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.

7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall

appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.

7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given

by the shareholders at a majority of three quarters of the share capital.

7.5 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of

the transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

7.6 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject

to the approval of such transfer given by the surviving shareholders at a majority of three quarters of the share capital.
Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving
spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.

Art. 8. Liquidation and sale preferences.
8.1 In case (i) of any sale of at least 50% of all shares in the Company, or a swap or a take-over of the Company in an

economically comparable way in a single or more related transactions or in close time proximity to one another, or (ii)
of the liquidation of the Company or (iii) of any sale or transfer of shares in the Company either to third parties or other
shareholders that would result in either more than 50% of the share capital or more than 50% of the voting rights being
owned by the acquiring party/parties (change of control) as a result of one or more related acquisitions (each of the
events described in (i), (ii) and (iii) is hereinafter referred to as a “Liquidity Event”), the proceeds (“Exit Proceeds”) -
subject to Article 8.2 below - will be distributed in accordance with Article 8.3 to the shareholders pro rata to their
participation in the Liquidity Event.

8.2 On a first level (“First Level”) the respective shareholder shall receive an amount equal to its total investment

made in the Company in order to acquire the respective Series A Shares held by it, consisting of the nominal amount of
the Series A Shares acquired and any share premium and/or other capital contribution (account 115) paid by it to the
Company.

8.3 After the payments on the First Level have been made, the remaining Exit Proceeds shall be allocated on a second

level (“Second Level”) to all selling Shareholders pro rata to their participation in the Liquidity Event. Any amounts received
by any shareholder on the First Level shall reduce the amount to be allocated to such shareholder on this Second Level
provided that no shareholder shall be obliged to repay any amount received on the First Level. Irrespective of whether
or not the sale of shares is made in one Liquidity Event or after the Liquidity Event in one transaction or more transactions,
no shareholder shall receive for the sale of all of its shares (and shall repay any exceeding amount to the other share-

187751

L

U X E M B O U R G

holders) an amount exceeding the higher of (i) its share in the total Exit Proceeds or proceeds pro rata to the shares
sold on a common equivalent basis or (ii) the amount allocated to such shareholder on the First Level and/or Second
Level from a subsequent sale. All rights related to the liquidity preference stipulated herein can only be exercised once.

8.4 The preferred allocation of Exit Proceeds on the First Level applies for the benefit of the respective shareholder

so long as the respective shareholder has not yet received the full amount that is to be allocated to such shareholder
according to the First Level.

C. Decisions of the shareholders

Art. 9. Collective decisions of the shareholders.
9.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles

of association.

9.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
9.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise

conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case,
each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his
vote in writing.

9.4 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of

shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by
the sole shareholder.

Art. 10. General meetings of shareholders. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, at least

one general meeting of shareholders shall be held within six (6) months of the end of each financial year in Luxembourg
at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the convening notice of such meeting.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices
of meeting. If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived
any convening requirement, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 11. Quorum and vote.
11.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
11.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company's

shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share
capital. If this majority is not reached in a first meeting or proposed written resolution, the shareholders may be convened
a second time with the same agenda or receive such proposed written resolution a second time by registered letter,
decisions are validly adopted in so far as they are adopted by a majority of the votes validly cast whichever is the fraction
of the share capital represented.

Art. 12. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.

Art. 13. Amendments of the articles of association. Any amendment of the articles of association requires the approval

of (i) a majority of shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.

D. Management

Art. 14. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
14.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers

form a board of managers.

14.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not

expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of
association is to be construed as a reference to the “sole manager”.

14.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any

actions necessary or useful to fulfil the Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the
Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.

Art. 15. Appointment, removal and term of office of managers.
15.1 The manager(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remune-

ration and term of office.

15.2 The managers shall be appointed and may be removed from office at any time, with or without cause, by a decision

of the shareholders representing more than half of the Company's share capital.

15.3 The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two (2) different classes, being class A

managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant
shareholders resolutions and the managers be identified with respect to the class they belong.

187752

L

U X E M B O U R G

Art. 16. Vacancy in the office of a manager.
16.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or

otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the  replaced  manager by  the remaining managers  until  the next meeting  of shareholders  which  shall  resolve on the
permanent appointment, in compliance with the applicable legal provisions.

16.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company's sole manager, such vacancy must be filled without undue

delay by the general meeting of shareholders.

Art. 17. Convening meetings of the board of managers.
17.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held

at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.

17.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four (24) hours at

least in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document
being sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location
determined in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.

17.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive

any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of
managers.

Art. 18. Conduct of meetings of the board of managers.
18.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not

need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

18.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may

appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any
such meeting.

18.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either

in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.

18.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other

means of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis
and allowing an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a
participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.

18.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or

represented at a meeting of the board of managers.

18.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,

if any, shall not have a casting vote. In the event where the general meeting of shareholders has appointed different classes
of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only be validly
taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which may be
represented).

18.7. The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in

writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be
the date of the last signature.

Art. 19. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
19.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by

the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. In the event the general meeting of
shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers), such minutes
shall be signed by one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation). Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman,
if any, or by any two (2) managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of
managers (namely class A managers and class B managers), such copies or excerpts shall be signed by one (1) class A
manager and one (1) class B manager (including by way of representation).

19.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or

excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.

Art. 20. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the

signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers;
in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers

187753

L

U X E M B O U R G

and class B managers), the Company will only be validly bound by the joint signatures of at least one (1) class A manager
and one (1) class B manager (including by way of representation) or (ii) by the joint signatures or the sole signature of
any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such
delegation.

E. Audit and supervision

Art. 21. Auditor(s).
21.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company

shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.

21.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting

of shareholders.

21.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
21.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d'entreprises agréé

(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies' register and the
accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.

21.5. An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its

approval.

F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends

Art. 22. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end

on the thirty-first of December of the same year.

Art. 23. Annual accounts and allocation of profits.
23.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of

the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.

23.2. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve.

This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten
per cent (10%) of the share capital of the Company.

23.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the

contributing shareholder agrees with such allocation.

23.4 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does

not exceed ten per cent (10%) of the share capital.

23.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the

remainder of the Company's profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.

23.6 Subject to Article 8, distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they

hold in the Company.

Art. 24. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
24.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared

by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may
not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable
reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles
of association do not allow to be distributed.

24.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the share-

holders subject to the provisions of the Law and these articles of association.

G. Liquidation

Art. 25. Liquidation.
25.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the

liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders
deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided,
the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the
Company.

25.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the shareholders in proportion to the number of shares of the Company held by them.

H. Final clause - Governing law

Art. 26. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance

with the Law.

187754

L

U X E M B O U R G

<i>Transitional provisions

1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 31 December

2014.

2. Interim dividends may be distributed during the Company's first financial year.

<i>Subscription and payment

The one thousand two hundred fifty (1,250) common shares and eleven thousand two hundred fifty (11,250) series A

shares, with a nominal value of one euro (EUR 1) each, issued have been subscribed by Emerging Markets Online Food
Delivery Holding S.à r.l., aforementioned, for the price of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500).

The shares so subscribed are fully paid-up by a contribution in cash so that the amount of twelve thousand five hundred

euro (EUR 12,500) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

The total contribution in the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) is entirely allocated to the

share capital.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be

borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately EUR 1,500.-.

<i>Resolutions of the sole shareholder

The incorporating shareholder, representing the entire share capital of the Company and having waived any convening

requirements, has thereupon passed the following resolutions:

1. The address of the registered office of the Company is set at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of

Luxembourg.

2. The following person is appointed as class A manager of the Company for an unlimited term:
- Mr Ralf Wenzel, born in Berlin, Germany, on 8 August 1979, professionally residing at Johannisstrasse 20, D-10117

Berlin, Germany.

The following person is appointed as class B manager of the Company for an unlimited term:
- Mr Ulrich Binninger, born in Trier, Germany, on 30 August 1966, professionally residing at 56, route de Trèves,

L-2633 Senningerberg, Luxembourg.

3. Any one manager of the Company, regardless of his category, is authorized to sign solely, on behalf of the sole

shareholder, the shareholders register of the Company that will be created upon incorporation of the Company.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,

this deed is worded in English followed by a German translation; at the request of the same appearing party and in case
of divergence between the English and the German text, the English version shall prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name

and residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausendvierzehn, am siebten November.
Vor uns, Maître Henri Hellinckx, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

IST ERSCHIENEN:

Emerging Markets Online Food Delivery Holding S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à res-

ponsabilité  limitée),  gegründet  und  bestehend  unter  dem  Recht  des  Großherzogtums  Luxemburg,  eingetragen  im
Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 175.738, mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Sennin-
gerberg, Großherzogtum Luxemburg,

hier vertreten durch Herr Philippe Sylvestre, LL.M., geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 1.

November 2014, ausgestellt in Berlin, Deutschland und vom 31. Oktober 2014, ausgestellt in Luxemburg, Großherzogtum
Luxemburg.

Besagte Vollmacht, welche von dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei und dem Notar ne varietur paraphiert

wurde, wird der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.

Die erschienene Partei hat den amtierenden Notar ersucht, die Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung

(société à responsabilité limitée) zu beurkunden, welche sie mit der folgenden Satzung gründen möchte:

187755

L

U X E M B O U R G

A. Name - Zweck - Dauer - Sitz

Art. 1. Name - Rechtsform. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée)

mit dem Namen Food Delivery Holding 5. S.à r.l. (die „Gesellschaft”), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10.
August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Ge-

sellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder
auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kontrolle
und Entwicklung ihrer Beteiligungen im Hinblick auf deren Verwertung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Artikel

2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder

Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören Garantien geben,
Sicherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.

2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere

durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und
Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheine bzw. Wertpapieren.

2.4 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur vornehmen

sowie solche, welche das geistige Eigentum betreffen oder im Zusammenhang mit Grundeigentum stehen und die ihr zur
Erreichung dieser Zwecke förderlich erscheinen.

Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden,

welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird.

Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Rates der Geschäftsführer

verlegt werden. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderli-
chen Art und Weise gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer im

Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.

4.4 Sollte der Rat der Geschäftsführer entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale

Entwicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an
ihrem  Gesellschaftssitz  beeinträchtigen  könnten,  so  kann  der  Gesellschaftssitz  bis  zur  endgültigen  Beendigung  dieser
außergewöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben
keine Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes
eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500), aufgeteilt in:
5.1.1 eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Stammanteile mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1) (die

„Stammanteile“); und

5.1.2 elftausendzweihundertfünfzig (11.250) Anteile der Serie A mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1)

(die „Anteile der Serie A“).

5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-

zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.

5.3 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen.

Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit jeweils dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht über-

schreiten darf.

6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs, die Insolvenz

oder ein vergleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.

187756

L

U X E M B O U R G

Art. 7. Anteilsregister - Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden

kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.

7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten

wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft
ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.

7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.
7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern mit

einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden.

7.5 Jede Übertragung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten gemäß Artikel 1690 des Code Civil

wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung zugestimmt
hat.

7.6 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters an neue Gesellschafter nur mit Zustimmung von

Gesellschaftern mit einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden. Eine derartige Zu-
stimmung ist nicht erforderlich, wenn die Anteile an Eltern, Nachkommen oder den/die überlebende/n Ehepartner/in
übertragen werden oder jedem anderem gesetzlichen Erben des verstorbenen Gesellschafters.

Art. 8. Liquidations- und Verkaufspräferenzen.
8.1 Im Falle (i) eines Verkaufs von mindestens 50% aller Anteile an der Gesellschaft oder eines Tausches oder einer

Übernahme der Gesellschaft in wirtschaftlich vergleichbarer Weise in einer oder mehreren Transaktionen oder in zeit-
licher Nähe zueinander, oder (ii) der Liquidation der Gesellschaft oder (iii) des Verkaufs oder der Übertragung von
Anteilen an der Gesellschaft entweder an Dritte oder an andere Gesellschafter, was dazu führen würde, dass entweder
mehr als 50% des Gesellschaftskapitals oder mehr als 50% der Stimmrechte im Besitz der erwerbenden Partei bzw.
Parteien wären (change of control), als Ergebnis eines oder mehrerer verbundener Akquisitionen, (wobei jeder der unter
(i), (ii) und (iii) beschriebenen Fälle im Folgenden als „Liquiditätsereignis“ bezeichnet wird), werden die Erlöse („Exiter-
löse“) - vorbehaltlich des Artikels 8.2 - im Einklang mit Artikel 8.3 auf einer pro rata-Basis entsprechend ihrer Beteiligung
am Liquiditätsereignis an die Gesellschafter verteilt.

8.2 Auf einer ersten Ebene („Erste Ebene”) erhält der jeweilige Gesellschafter einen Betrag, welcher dem Betrag seiner

jeweiligen Gesamtinvestition in die Gesellschaft entspricht, welche er aufgebracht hat, um Anteile der Serie A zu erwerben,
bestehend aus dem Nominalwert der Anteile der Serie A und dem Agio und/oder anderen Kapitaleinlage (Konto 115 des
Standardisierten Luxemburgischen Kontenplans), die von diesem Gesellschafter an die Gesellschafter gezahlt wurden.

8.3 Nachdem die Zahlungen auf der Ersten Ebene geleistet wurden, werden die übrigen Exiterlöse auf einer zweiten

Ebene („Zweite Ebene“) an alle verkaufenden Gesellschafter auf einer pro rata-Basis entsprechend ihrer Beteiligung am
Liquiditätsereignis verteilt. Sämtliche von einem Gesellschafter auf der Ersten Ebene erhaltenen Beträge mindern den von
diesem Gesellschafter zu erhaltenden Betrag auf dieser Zweiten Ebene mit der Maßgabe, dass kein Gesellschafter zur
Rückzahlung eines auf der Ersten Ebene erhaltenen Betrags verpflichtet ist. Die Zuteilung auf der Gemeinsamen Ebene
erfolgt solange, bis alle Exiterlöse an die Gesellschafter verteilt wurden. Unabhängig davon, ob der Verkauf von Anteilen
während eines Liquiditätsereignisses oder danach in einer oder mehreren Transaktionen erfolgt oder nicht, hat kein
Gesellschafter für den Verkauf all seiner Anteile einen Betrag zu erhalten (und übersteigende Beträge an die anderen
Gesellschafter zurückzuzahlen), der höher ist, (i) als sein Anteil an der Gesamtheit der Exiterlöse oder Erlöse auf einer
pro rata-Basis zu den Anteilen, die auf einer gemeinsamen und gleichwertigen Basis verkauft wurden oder (ii) als der
Betrag, der diesem Gesellschafter auf der Ersten und/oder Zweiten Ebene aus einem späteren Verkauf zugeteilt wurde.
Sämtliche mit der hierin festgelegten Liquiditätspräferenz verbundenen Rechte können nur einmal ausgeübt werden.

8.4 Die bevorzugte Zuteilung von Exiterlösen auf der Ersten Ebene gilt zugunsten des jeweiligen Gesellschafters so

lange, wie der jeweilige Gesellschafter noch nicht den ihm auf der Ersten Ebene zustehenden Gesamtbetrag erhalten hat.

C. Entscheidungen der Gesellschafter

Art. 9. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
9.1 Die Gesellschafterversammlung ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch das Gesetz und diese Satzung

übertragen wurden.

9.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.
9.3 Falls und solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, dürfen gemeinsame Ent-

scheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung vorbehalten wären, schriftlich gefasst werden. In diesem
Fall  erhält  jeder  Gesellschafter  den  Text  der  Beschlüsse  oder  Entscheidungen  in  ausformulierter  Form  und  übt  sein
Stimmrecht schriftlich aus.

9.4 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschriften

des Abschnitts XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jeder Bezug auf die „Gesellschafter-

187757

L

U X E M B O U R G

versammlung“ in der vorliegenden Satzung als Bezug auf den Alleingesellschafter, je nach Zusammenhang und soweit
anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingesellschafter ausgeübt.

Art. 10. Gesellschafterversammlung. Falls die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, muss jähr-

lich innerhalb von sechs (6) Monaten vor dem Ende des Geschäftsjahres mindestens eine Gesellschafterversammlung in
Luxemburg am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort abgehalten werden, wie in der Einberufungsbekanntma-
chung zu dieser Versammlung genauer bestimmt. Andere Gesellschafterversammlungen finden an dem Ort und zu der
Zeit  statt,  welcher  in  der  entsprechenden  Einberufungsbekanntmachung  genauer  bestimmt  werden.  Falls  alle  Gesell-
schafter in einer Versammlung anwesend oder vertreten sind und auf sämtliche Einberufungsformalitäten verzichtet haben,
kann die Gesellschafterversammlung auch ohne vorherige Ankündigung oder Veröffentlichung abgehalten werden.

Art. 11. Quorum und Abstimmung.
11.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.
11.2 Vorbehaltlich anderer Regelungen dieser Satzung oder des Gesetzes, die ein höheres Mehrheitsverhältnis vor-

sehen, bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von Gesellschaftern, die mehr als die
Hälfte des Gesellschaftskapitals halten. Falls diese Mehrheit in einer ersten Gesellschafterversammlung oder einer ersten
schriftlichen Konsultation der Gesellschafter nicht erreicht wird, können die Anteilseigner ein weiteres Mal mit derselben
Tagesordnung einberufen werden oder per Einschreiben dieselben schriftlichen Beschlussvorschläge erhalten und Ent-
scheidungen werden wirksam mit der Mehrheit der wirksam abgegebenen Stimmen gefasst, unabhängig vom Anteil des
durch sie vertretenen Gesellschaftskapitals.

Art. 12. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.

Art. 13. Änderung der Satzung. Eine Änderung der Satzung erfordert die Zustimmung (i) einer Mehrheit der Gesell-

schafter, die (ii) mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertritt.

D. Geschäftsführung

Art. 14. Befugnisse des alleinigen Geschäftsführers - Zusammensetzung und Befugnisse des Rates der Geschäftsführer.
14.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Ge-

schäftsführer hat, bilden diese einen Rat der Geschäftsführer.

14.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „alleiniger Ge-

schäftsführer“ nicht ausdrücklich verwendet wird, ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Rat der Geschäftsführer“
als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer“ auszulegen.

14.3 Der Rat der Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse im Namen der Gesellschaft zu handeln

und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.

Art. 15. Ernennung, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
15.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung ernannt, welche ihre Bezüge und

Amtszeit festlegt.

15.2 Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund durch einen Beschluss von Gesellschaftern, die mehr als die

Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, ernannt oder abberufen werden.

15.3 Die Gesellschafterversammlung kann die Ernennung von Geschäftsführern zwei (2) unterschiedlicher Kategorien

beschließen, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Eine solche Klassifizierung
der Geschäftsführer muss ordnungsgemäß im Protokoll der betreffenden Gesellschafterbeschlüsse festgehalten und die
Geschäftsführer der Kategorie, der sie angehören, zugeordnet werden.

Art. 16. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
16.1 Scheidet ein Geschäftsführer durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Insolvenz, Rücktritt oder aus einem anderen Grund

aus seinem Amt aus, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen die ur-
sprüngliche Amtszeit nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesellschafterversammlung ausgefüllt werden,
welche im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die endgültige Ernennung entscheidet.

16.2  Für  den Fall,  dass  der alleinige  Geschäftsführer  aus  seinem Amt ausscheidet,  muss  die frei gewordene Stelle

unverzüglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.

Art. 17. Einladung zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
17.1 Der Rat der Geschäftsführer versammelt sich auf Einberufung eines beliebigen Geschäftsführers. Die Sitzungen

des Rates der Geschäftsführer finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.

17.2  Die  Geschäftsführer  werden  mindestens  vierundzwanzig  (24)  Stunden  vor  dem  für  die  Sitzung  anberaumten

Zeitpunkt zu jeder Sitzung des Rates der Geschäftsführer schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe
der Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Geschäftsführer
schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abgege-
ben haben, wobei eine Kopie eines solchen unterzeichneten Dokuments ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung

187758

L

U X E M B O U R G

zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss
des Rates der Geschäftsführer bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.

17.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle

Einladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Rates
der Geschäftsführer diesen zugestimmt und sie unterzeichnet haben.

Art. 18. Durchführung von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
18.1 Der Rat der Geschäftsführer kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Rat der Ge-

schäftsführer kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise selbst ein Geschäftsführer sein muss
und der für die Protokollführung der Sitzungen des Rates der Geschäftsführer verantwortlich ist.

18.2 Sitzungen des Rates der Geschäftsführer werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Rates der Ge-

schäftsführer  geleitet.  In  dessen  Abwesenheit  kann  der  Rat  der  Geschäftsführer  ein  anderes  Mitglied  des  Rates  der
Geschäftsführer  durch  einen  Mehrheitsbeschluss  der  anwesenden  oder  vertretenen  Mitglieder  als  Vorsitzenden  pro
tempore ernennen.

18.3 Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer teilnehmen, indem er ein anderen

Geschäftsführer schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder durch ein anderes vergleichbares Kommunikationsmittel be-
vollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Geschäftsführer kann einen
oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.

18.4 Eine Sitzung des Rates der Geschäftsführer kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein

anderes Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu
hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel
ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung gilt als am Sitz der Ge-
sellschaft abgehalten.

18.5 Der Rat der Geschäftsführer kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest die Mehrheit seiner

Mitglieder in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.

18.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Rates der Geschäftsführer

teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden,
hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme. Sofern die Gesellschafterversammlung jedoch unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden Beschlüsse des Rates der Geschäftsführer nur dann wirksam gefasst, wenn sie von der Mehrheit
der Geschäftsführer einschließlich mindestens eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsführers der
Kategorie B (oder deren Vertreter) gefasst werden.

18.7 Der Rat der Geschäftsführer kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung,

per Faxschreiben, E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Jeder Geschäftsführer kann seine
Zustimmung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreffenden
Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.

Art. 19. Protokoll von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer; Protokoll der Entscheidungen des alleinigen Ge-

schäftsführers.

19.1 Das Protokoll einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer wird vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer,

falls vorhanden oder, im Falle seiner Abwesenheit, vom Vorsitzenden pro tempore und dem Schriftführer (falls vorhanden)
oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche
Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kate-
gorie B), werden solche Protokolle von einem (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einem (1) Geschäftsführer der
Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet. Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsver-
fahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer, falls
vorhanden, oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden solche Kopien oder Auszüge von einem (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einem (1)
Geschäftsführer der Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet.

19.2 Die Entscheidungen des alleinigen Geschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom alleinigen

Geschäftsführer unterzeichnet wird. Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet.

Art. 20. Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Um-

ständen  durch  (i)  die  Unterschrift  des  alleinigen  Geschäftsführers  oder,  für  den  Fall,  dass  die  Gesellschaft  mehrere
Geschäftsführer hat, durch die gemeinsame Unterschrift zwei (2) beliebiger Geschäftsführer wirksam verpflichtet; sofern
die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer
der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B), wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift min-
destens  eines  (1)  Geschäftsführers  der  Kategorie  A  und  eines  (1)  Geschäftsführers  der  Kategorie  B  (oder  deren
Vertreter), oder (ii) durch die gemeinsamen Unterschriften oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/
denen eine Unterschriftsbefugnis durch den Rat der Geschäftsführer übertragen worden ist, wirksam verpflichtet.

187759

L

U X E M B O U R G

E. Aufsicht und Prüfung der gesellschaft

Art. 21. Rechnungsprüfer / Wirtschaftsprüfer.
21.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der

Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)). Die Gesellschafterversammlung
ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.

21.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
21.3 Die Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Recht der permanenten Überprüfung und Kontrolle aller Ge-

schäfte der Gesellschaft.

21.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember

2002  betreffend  das  Handelsregister  und  die  Buchhaltung  und  den  Jahresabschluss  von  Unternehmen,  in  der  jeweils
gültigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d'entreprise agréé(s)) ernennen, entfällt
die Funktion des Rechnungsprüfers.

21.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die

Gesellschafterversammlung abberufen werden.

F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinne - Abschlagsdividenden

Art. 22. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am

einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

Art. 23. Jahresabschluss und Gewinne.
23.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Rat der Geschäftsführer erstellt im

Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und
Verlustrechnung.

23.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage

der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.

23.3  Durch  einen  Gesellschafter  erbrachte  Einlagen  in  Rücklagen  können  mit  Zustimmung  dieses  Gesellschafters

ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.

23.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage entsprechend herabgesetzt

werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.

23.5 Auf Vorschlag des Rates der Geschäftsführer bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den ge-

setzlichen  Vorschriften  und  den  Bestimmungen  dieser  Satzung  wie  der  verbleibende  Bilanzgewinn  der  Gesellschaft
verwendet werden soll.

23.6 Vorbehaltlich des Artikels 8 erfolgen Ausschüttungen an die Gesellschafter proportional zur Anzahl der von ihnen

an der Gesellschaft gehaltenen Anteile.

Art. 24. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
24.1 Der Rat der Geschäftsführer kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche

vom Rat der Geschäftsführer vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur
Verfügung stehen. Der ausschüttbare Betrag darf nicht die Summe der seit dem Ende des vergangenen Geschäftsjahres
angefallenen Gewinne, gegebenenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne und ausschüttbare Rücklagen, beziehungs-
weise vermindert durch vorgetragene Verluste und Summen, die einer Rücklage zugeführt werden, welche nach dem
Gesetz von 1915 oder dieser Satzung nicht ausgeschüttert werden darf, übersteigen.

24.2 Das Agio, andere Kapitalreserven oder andere ausschüttbare Rücklagen können, im Einklang mit den Bestim-

mungen des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung, frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

G. Liquidation

Art. 25. Liquidation.
25.1 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Liquidation durch einen

oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, die über die Auflö-
sung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit nichts anderes
bestimmt wird haben die Liquidatoren die weitestgehenden Rechte für die Verwertung der Vermögenswerte und die
Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

25.2 Der sich nach Verwertung der Vermögenswerte und Tilgung der Verbindlichkeiten ergebende Überschuss wird

an die Gesellschafter proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehaltenen Anteile verteilt.

H. Schlussbestimmungen - Anwendbares recht

Art. 26. Anwendbares Recht. Für alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten gelten die Regelungen des

Gesetzes von 1915.

187760

L

U X E M B O U R G

<i>Übergangsbestimmungen

1. Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember

2014.

2. Abschlagsdividenden können auch während des ersten Geschäftsjahres der Gesellschaft ausgeschüttet werden.

<i>Zeichnung und Zahlung

Die eintausendzweihundertfünfzig (1.250) ausgegebenen Stammanteile und die elftausendzweihundertfünfzig (11.250)

ausgegebenen Anteile der Serie A mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1) wurden durch Emerging Markets
Online Food Delivery Holding S.à r.l., vorbenannt, zum Preis von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) gezeichnet.

Die Einlage für so gezeichnete Anteile wurde vollständig in bar erbracht, so dass der Gesellschaft ein Betrag in Höhe

von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) zur Verfügung steht, was dem unterzeichnenden Notar nachgewiesen
wurde.

Die gesamte Einlage von in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) wird vollständig dem Gesellschafts-

kapital zugeführt.

<i>Auslagen

Die der Gesellschaft aufgrund oder im Zusammenhang mit ihrer Gründung entstandenen Kosten, Gebühren, Honorare

und Auslagen werden auf EUR 1.500,- geschätzt.

<i>Beschlüsse des alleingesellschafters

Der Gründungsgesellschafter, welcher das gesamte Gesellschaftskapital repräsentiert und auf eine formelle Einberu-

fungsbekanntmachung verzichtet, hat daraufhin folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Sitz der Gesellschaft ist in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
2. Die folgende Person wird für unbegrenzte Zeit als Geschäftsführer der Kategorie A der Gesellschaft ernannt:
- Herr Ralf Wenzel, geboren am 8. August 1979 in Berlin, Deutschland, geschäftsansässig in Johannisstrasse 20, D-10117

Berlin, Deutschland.

Die folgende Person wird für unbegrenzte Zeit als Geschäftsführer der Kategorie B der Gesellschaft ernannt:
- Herr Ulrich Binninger, geboren am 30. August 1966 in Trier, Deutschland, geschäftsansässig in 56, route de Trèves,

L-2633 Senningerberg, Luxemburg.

3. Jeder einzelne der Geschäftsführer der Gesellschaft ist, ungeachtet seiner Kategorie, dazu ermächtigt, das Anteilin-

haberregister, welches am Tag der Gründung der Gesellschaft erstellt wird, im Namen des Alleingesellschafters alleine
zu unterzeichnen.

Worüber diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen wurde.
Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache beherrscht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende

Urkunde auf Verlangen der erschienenen Partei auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung;
auf Verlangen besagter erschienener Partei und im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen
Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.

Die vorstehende Urkunde ist der Bevollmächtigten der erschienenen Partei, welche dem Notar mit Namen, Vornamen

und Wohnsitz bekannt ist, verlesen und vom Notar gemeinsam mit dieser Bevollmächtigten unterzeichnet worden.

Gezeichnet: P. SYLVESTRE und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 12 novembre 2014. Relation: LAC/2014/53222. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - Der Gesellschaft auf Begehr erteilt.

Luxemburg, den 28. November 2014.

Référence de publication: 2014190204/640.
(140212183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2014.

St August Lux Intermediate Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 25.000,00.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, routes de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 192.214.

STATUTES

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-first day of November.
Before the undersigned, Henri BECK, notary resident in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

187761

L

U X E M B O U R G

was held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of August Cayman Intermediate Holdco, Inc.,

a company governed by the laws of the Cayman Islands, whose registered office is at Maples Corporate Services Limited,
PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands and registered with the Registrar of Companies
of the Cayman Islands under number MC-266689 (the Company).

THERE APPEARED:

August Cayman Company, Inc., a company governed by the laws of the Cayman Islands, whose registered office is at

Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands and regis-
tered with the Registrar of Companies of the Cayman Islands under number MC 266688 (the Sole Shareholder),

here represented by Peggy Simon, notary clerk, with professional address at L-6475 Echternach, 9, Rabatt, by virtue

of a proxy given under private seal.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and

the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed together with it with the registration
authorities.

The appearing party, represented as set out above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. the Sole Shareholder represents the entire share capital of the Company.
II. the Company’s capital is presently set at twenty-five thousand United States Dollars (USD 25,000.-), represented

by twenty-five thousand (25,000) shares in registered form, with a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-),
all subscribed and fully paid up.

III. under the laws of the Cayman Islands, the Company may transfer its registered office, principal establishment,

central administration and place of management to the Grand-Duchy of Luxembourg, following which, the entity ceases
to be a Cayman Islands company, and the migrated entity in such jurisdiction is, for the purposes of all the laws of Cayman
Islands, deemed to be the same entity as the Company prior to the migration, and the existence of the Company continues
after the migration.

IV. that by resolutions validly adopted by (i) the Sole Shareholder of the Company on November 21, 2014, acting in

accordance with the articles of association of the Company, and (ii) the board of directors of the Company on November
21, 2014, duly resolved to convert the Company to a Luxembourg Company, such conversion being effective as from the
date hereof without the Company being dissolved but to the contrary with full corporate and legal continuance. All
formalities required under applicable laws to give effect to those resolutions including the passing of the necessary re-
solutions (being the Sole Shareholder resolutions and the board of directors resolutions) in the Cayman Islands have been
duly performed. A copy of said resolutions shall remain annexed to the present deed.

V. that (i) an interim balance sheet of the Company dated November 21, 2014 (the Balance Sheet) and (ii) a management

certificate dated November 21, 2014 (the Management Certificate) indicates that, the net worth of the Company is
estimated to be at least twenty-five thousand United States Dollars (USD 25,000.-). A copy of the Balance Sheet and the
Management Certificate, after having been signed ne varietur by the undersigned notary and the proxyholder acting on
behalf  of  the  appearing  party,  shall  remain  attached  to  the  present  deed  and  shall  be  filed  with  such  deed  with  the
registration authorities.

VI. that the agenda of the Meeting is as follows:
(a) transfer of the Company’s registered office, principal establishment, central administration and place of management

from the Cayman Islands to the Grand Duchy of Luxembourg, with effect as from the date of the Meeting, without the
Company being dissolved but, on the contrary, with full corporate and legal continuance;

(b) adoption by the Company of the legal form of a private limited liability company (société à responsabilité limitée)

with its name ST August Lux Intermediate Holdco S.à r.l., and acceptance of Luxembourg nationality arising from the
transfer of the Company’s registered office, principal establishment, central administration and place of management to
the Grand Duchy of Luxembourg;

(c) approval of the opening Balance Sheet of the Company as from the date of the Meeting and confirmation of the

description and consistency of all the assets and liabilities of the Company and of the paid-up issued share capital of the
Company;

(d) establishment of the share capital and allocation to the share premium and/or legal reserve, if any;
(e) amendment and complete restatement of the Company’s articles of association to conform them to the laws of

the Grand Duchy of Luxembourg, as a consequence of the Company becoming a Luxembourg law governed company
subject to the Luxembourg law on commercial companies dated 10 August, 1915, as amended;

(f) acknowledgment of the resignation of the directors of the Company and vote of discharge and appointment of the

new managers of the Company;

(g) establishment of the Company’s registered office, principal establishment, central administration and place of ma-

nagement at 6D, route de Trèves, L-2633, Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg;

(h) granting of powers.
VII. that the Meeting has taken the following resolutions:

187762

L

U X E M B O U R G

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to transfer the Company’s registered office, principal establishment, central adminis-

tration and place of management of the Company from the Cayman Islands to the Grand Duchy of Luxembourg with
immediate effect, without the Company being dissolved but on the contrary with full corporate and legal continuance.
The Sole Shareholder further declares that all formalities required under the laws of the Cayman Islands to give effect to
such transfer have been duly performed.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolves that the Company (i) adopts the form of a private limited liability company (société à

responsabilité limitée) with the name ST August Lux Intermediate Holdco S.à r.l., (ii) accepts the Luxembourg nationality
resulting from the transfer of the registered office, principal establishment, central administration and place of management
of the Company to Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, and (iii) shall as from the date of the present deed be
subject to the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.

<i>Third resolution

The Sole Shareholder resolves to approve the Company’s interim balance sheet dated November 21, 2014 confirming

that the net asset value of the Company amounts to at least the legal minimum share capital of the Company.

The Sole Shareholder records that the description and amount of all the assets and liabilities of the Company result

from the aforementioned Balance Sheet.

The Sole Shareholder states that all the assets and liabilities of the Company, without limitation, remain the ownership

in the entirety of the Company, which continues to own all its assets and continues to be obliged by all its liabilities and
commitments.

<i>Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves (i) establish the share capital of the Company at twenty-five thousand united states

dollars (USD 25,000.-) represented by twenty-five thousand (25,000) shares having a nominal value of one united states
dollar (USD 1.-) each, and (ii) allocate an amount of two thousand five hundred united states dollars (USD 2,500.-) to the
legal reserve account of the Company.

<i>Fifth resolution

As a result of the foregoing resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend and completely restate the articles

of association of the Company so as to conform them to Luxembourg laws.

The restated articles of association of the Company shall read as follows:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. The name of the company is “ST August Lux Intermediate Holdco S.à r.l.” (the Company). The Company

is a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Lu-
xembourg, in particular the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), and these articles
of incorporation (the Articles).

Art. 2. Registered office.
2.1. The Company’s registered office is established in Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be trans-

ferred within that municipality by a resolution of the board of managers. It may be transferred to any other location in
the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed
for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a

resolution of the board of managers. If the board of managers determines that extraordinary political or military deve-
lopments or events have occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal
activities of the Company at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely
ceased. Any such temporary measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Corporate object.
3.1. The Company’s object is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enter-

prises in any form whatsoever, and the management of those participations. The Company may in particular acquire, by
subscription, purchase and exchange or in any other manner, any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and, more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. Further, it may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other
intellectual property rights of any nature or origin.

187763

L

U X E M B O U R G

3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. It may lend funds, including, without limitation, the proceeds
of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. It may also give guarantees and pledge,
transfer, encumber or otherwise create and grant security over some or all of its assets to guarantee its own obligations
and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the
avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated financial sector activities without having obtained the
requisite authorisation.

3.3. The Company may use any techniques, legal means and instruments to manage its investments efficiently and

protect itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect

to real estate or movable property which, directly or indirectly, favours or relates to its corporate object.

Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period.
4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,

bankruptcy or any similar event affecting one or more shareholders.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.
5.1. The share capital is set at twenty-five thousand united states dollars (USD 25,000), represented by twelve thousand

five hundred (25,000) shares in registered form, having a nominal value of one united state dollar (USD 1.-) each.

5.2.  The  share  capital  may  be  increased  or  reduced  once  or  more  by  a  resolution  of  the  shareholders,  acting  in

accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

Art. 6. Shares.
6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
6.2. The shares are freely transferable between shareholders.
6.3. When the Company has a sole shareholder, the shares are freely transferable to third parties.
6.4. When the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject

to prior approval by shareholders representing at least three-quarters of the share capital.

6.5. A share transfer shall only be binding on the Company or third parties following notification to, or acceptance by,

the Company in accordance with article 1690 of the Luxembourg Civil Code.

6.6. A register of shareholders shall be kept at the registered office and may be examined by any shareholder on

request.

6.7. The Company may redeem its own shares, provided:
(i) it has sufficient distributable reserves for that purpose; or
(ii) the redemption results from a reduction in the Company’s share capital.

III. Management - Representation

Art. 7. Appointment and removal of managers.
7.1. The Company shall be managed by one or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which

sets the term of their office. The managers need not be shareholders.

7.2. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders.

Art. 8. Board of managers. If several managers are appointed, they shall constitute the board of managers, which will

be composed of one or several class A managers and one or several class B managers (the Board).

8.1. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholders by the Law or the Articles fall within the competence of the

Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s corporate
object.

(ii) The Board may delegate special or limited powers to one or more agents for specific matters.
8.2. Procedure
(i) The Board shall meet at the request of any two managers, at the place indicated in the convening notice, which in

principle shall be in the Grand-Duchy of Luxembourg.

(ii) Written notice of any Board meeting shall be given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance,

except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the notice.

(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and each of them states that they

have full knowledge of the agenda for the meeting. A manager may also waive notice of a meeting, either before or after

187764

L

U X E M B O U R G

the meeting. Separate written notices are not required for meetings which are held at times and places indicated in a
schedule previously adopted by the Board.

(iv) A manager may grant to another manager a power of attorney in order to be represented at any Board meeting.
(v) The Board may only validly deliberate and act if a majority of its members are present or represented. Board

resolutions shall be validly adopted by a majority of the votes of the managers present or represented, provided that if
the shareholder(s) have appointed one or several class A managers and one or several class B managers, at least one (1)
class A manager and one (1) class B manager votes in favour of the resolution. Board resolutions shall be recorded in
minutes signed by the chairperson of the meeting or, if no chairperson has been appointed, by all the managers present
or represented.

(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other means

of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation
by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.

(vii) Circular resolutions signed by all the managers (Managers’ Circular Resolutions) shall be valid and binding as if

passed at a duly convened and held Board meeting, and shall bear the date of the last signature.

8.3. Representation
(i) The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature of any class A manager and

any class B manager.

(ii) The Company shall also be bound towards third parties by the signature of any person to whom special powers

have been delegated by the Board.

Art. 9. Sole manager. If the Company is managed by a sole manager, all references in the Articles to the Board, the

managers or any manager are to be read as references to the sole manager, as appropriate.

Art. 10. Liability of the managers. The managers shall not be held personally liable by reason of their office for any

commitment they have validly made in the name of the Company, provided those commitments comply with the Articles
and the Law.

IV. Shareholder(s)

Art. 11. General meetings of shareholders and shareholders’ written resolutions.
11.1. Powers and voting rights
(i) Unless resolutions are taken in accordance with article 11.1.(ii), resolutions of the shareholders shall be adopted

at a general meeting of shareholders (each a General Meeting).

(ii) If the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25), resolutions of the shareholders

may be adopted in writing (Written Shareholders’ Resolutions).

(iii) Each share entitles the holder to one (1) vote.
11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders may be convened to General Meetings by the Board. The Board must convene a General Meeting

following a request from shareholders representing more than half of the share capital.

(ii) Written notice of any General Meeting shall be given to all shareholders at least eight (8) days prior to the date of

the meeting, except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in
the notice.

(iii) When resolutions are to be adopted in writing, the Board shall send the text of such resolutions to all the share-

holders. The shareholders shall vote in writing and return their vote to the Company within the timeline fixed by the
Board. Each manager shall be entitled to count the votes.

(iv) General Meetings shall be held at the time and place specified in the notices.
(v) If all the shareholders are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the

agenda of the General Meeting, it may be held without prior notice.

(vi) A shareholder may grant written power of attorney to another person (who need not be a shareholder), in order

to be represented at any General Meeting.

(vii) Resolutions to be adopted at General Meetings shall be passed by shareholders owning more than one-half of the

share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting, the shareholders shall be convened by registered
letter to a second General Meeting and the resolutions shall be adopted at the second General Meeting by a majority of
the votes cast, irrespective of the proportion of the share capital represented.

(viii) The Articles may only be amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least

three-quarters of the share capital.

(ix) Any change in the nationality of the Company and any increase in a shareholder’s commitment to the Company

shall require the unanimous consent of the shareholders.

(x) Written Shareholders’ Resolutions are passed with the quorum and majority requirements set forth above and

shall bear the date of the last signature received prior to the expiry of the timeline fixed by the Board.

187765

L

U X E M B O U R G

Art. 12. Sole shareholder. When the number of shareholders is reduced to one (1):
(i) the sole shareholder shall exercise all powers granted by the Law to the General Meeting;
(ii) any reference in the Articles to the shareholders, the General Meeting, or the Written Shareholders’ Resolutions

is to be read as a reference to the sole shareholder or the sole shareholder’s resolutions, as appropriate; and

(iii) the resolutions of the sole shareholder shall be recorded in minutes or drawn up in writing.

V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision

Art. 13. Financial year and approval of annual accounts.
13.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
13.2. Each year, the Board must prepare the balance sheet and profit and loss accounts, together with an inventory

stating the value of the Company’s assets and liabilities, with an annex summarising the Company’s commitments and the
debts owed by its manager(s) and shareholders to the Company.

13.3. Any shareholder may inspect the inventory and balance sheet at the registered office.
13.4. The balance sheet and profit and loss accounts must be approved in the following manner:
(i) if the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25), within six (6) months following

the end of the relevant financial year either (a) at the annual General Meeting (if held) or (b) by way of Written Share-
holders’ Resolutions; or

(ii) if the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), at the annual General Meeting.
13.5. If the number of shareholders exceed twenty-five (25), the annual General Meeting shall be held at the registered

office or at any other place within the municipality of the registered office, as specified in the notice, on the second Monday
of May of each year at 10.00 a.m. If that day is not a business day in the Grand-Duchy of Luxembourg, the annual General
Meeting shall be held on the following business day.

Art. 14. Auditors.
14.1. When so required by law, the Company’s operations shall be supervised by one or more approved external

auditors  (réviseurs  d’entreprises  agréés).  The  shareholders  shall  appoint  the  approved  external  auditors,  if  any,  and
determine their number and remuneration and the term of their office.

14.2. If the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), the Company’s operations shall be

supervised by one or more commissaires (statutory auditors), unless the law requires the appointment of one or more
approved external auditors (réviseurs d’entreprises agréés). The commissaires are subject to re-appointment at the annual
General Meeting. They may or may not be shareholders.

Art. 15. Allocation of profits.
15.1. Five per cent (5%) of the Company’s annual net profits must be allocated to the reserve required by law (the

Legal Reserve). This requirement ceases when the Legal Reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the
share capital.

15.2. The shareholders shall determine the allocation of the balance of the annual net profits. They may decide on the

payment of a dividend, to transfer the balance to a reserve account, or to carry it forward in accordance with the applicable
legal provisions.

15.3. Interim dividends may be distributed at any time, subject to the following conditions:
(i) the Board must draw up interim accounts;
(ii) the interim accounts must show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available

for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits made since the end of
the last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits carried forward and
distributable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be allocated to the Legal Reserve;

(iii) within two (2) months of the date of the interim accounts, the Board must resolve to distribute the interim

dividends; and

(iv) taking into account the assets of the Company, the rights of the Company’s creditors must not be threatened by

the distribution of an interim dividend.

If the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the Board has the right to

claim the reimbursement of dividends not corresponding to profits actually earned and the shareholders must immediately
refund the excess to the Company if so required by the Board.

VI. Dissolution - Liquidation

16.1. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted with the consent of a

majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders shall appoint
one or more liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation, and shall determine their number,
powers and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators shall have full power to realise
the Company’s assets and pay its liabilities.

187766

L

U X E M B O U R G

16.2. The surplus (if any) after realisation of the assets and payment of the liabilities shall be distributed to the share-

holders in proportion to the shares held by each of them.

VII. General provisions

17.1. Notices and communications may be made or waived, Managers’ Circular Resolutions and Written Shareholders

Resolutions may be evidenced, in writing, by fax, e-mail or any other means of electronic communication.

17.2. Powers of attorney may be granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with

Board meetings may also be granted by a manager, in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed

equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers’ Circular Resolutions, the resolutions adopted by the
Board by telephone or video conference or the Written Shareholders’ Resolutions, as the case may be, may appear on
one original or several counterparts of the same document, all of which taken together shall constitute one and the same
document.

17.4. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the applicable law

and, subject to any non-waivable provisions of the law, with any agreement entered into by the shareholders from time
to time.

<i>Sixth resolution

The Sole Shareholder resolves to acknowledge the resignation, effective as from the date hereof, of the directors of

the Company prior to the transfer of the Company’s registered office, principal establishment, central administration and
place of management from the Cayman Islands to the Grand Duchy of Luxembourg from their position as directors of
the Company and to grant them full discharge for the performance of their duties as from the date of their appointment
as directors of the Company until the date of their resignation.

The Sole Shareholder further resolves to appoint the following persons as managers of the Company for an unlimited

period:

<i>Class A Managers:

- Jim KIRSLIS, born in Massachusetts, United States of America on March 9, 1962, with address at 4 King Phillip Circle,

Rockland, MA 02370, United States of America; and

- Geert BRAAKSMA, born in Oostdongeradeel, the Netherlands, on July 2, 1957, with address at Vechtlaan 62, 7555

JZ Hengelo, the Netherlands.

<i>Class B Managers:

- Dylan DAVIES, born in Swansea, United Kingdom, on November 16, 1966, with address at 6D, route de Trèves,

L-2633 Senningerberg, Grand-Duchy of Luxembourg; and

- Cedric BRADFER, born in Chambery, France, on August 2, 1978, with address at 6D, route de Trèves, L-2633

Senningerberg, Grand-Duchy of Luxembourg.

<i>Seventh resolution

The Sole Shareholder resolves to establish the Company’s registered office, principal establishment, central adminis-

tration and place of management at 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.

<i>Eighth resolution

The  Sole  Shareholder  resolves  to  appoint  any  Class  B  Manager  of  the  Company  newly  appointed,  as  the  person

authorised to perform in the Grand Duchy of Luxembourg any acts and formalities in connection with the Company
moving its registered office, principal establishment, central administration and place of management from the Cayman
Islands to the Grand Duchy of Luxembourg, including the registration of the Company with the Luxembourg Register of
Commerce and Companies and the execution of any and all documents, deeds which may be deemed useful or necessary
in connection thereto.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the appearing party, this

deed is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of discrepancies, the English text prevails.

This notarial deed is drawn up in Echternach, on the date stated above.
After reading this deed aloud, the notary signs it with the appearing party’s authorised representative.

Suit la traduction française du texte qui précède

L’an deux mille quatorze, le vingt-et-unième jour de novembre,
Par devant le soussigné, Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg,

s’est tenue

187767

L

U X E M B O U R G

une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) de l’associé unique de August Cayman Intermediate Holdco, Inc.,

une société régie par le droit des Iles Caïmans, dont le siège social est établi à Maples Corporate Services Limited, PO
Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Iles Caïmans et immatriculée auprès du registre de commerce et des
sociétés des Iles Caïmans sous le numéro MC-26689 (la Société).

A COMPARU:

August Cayman Company, Inc., une société régie par les lois des Iles Caymans, avec siège social à Maples Corporate

Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Iles Caymans et immatriculée auprès du Registre
des Sociétés des Iles Caymans sous le numéro MC 266688 (l’Associé Unique),

ici représenté par Peggy Simon, clerc de notaire, de résidence professionnelle à L-6475 Echternach, 9, Rabatt, en vertu

d’une procuration donnée sous seing privé.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et

le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui auprès de l’enregistrement.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. l’Associé Unique représente l’intégralité du capital social de la Société.
II. le capital de la Société est actuellement fixé à vingt-cinq mille dollars américains (USD 25.000,-), représenté par

vingt-cinq mille (25.000) parts sociales sous forme nominative, ayant valeur nominale de un dollar américain (USD 1,-),
toutes souscrites et entièrement libérées.

III. en vertu des lois des Iles Caïmans, la Société peut transférer son siège social, principal établissement, administration

centrale et lieu de gestion au Grand-Duché de Luxembourg, après quoi, l’entité cesse d'être une société des Iles Caïmans,
et l’entité migrée dans cette juridiction est, aux fins des lois des Iles Caïmans, réputée être la même entité que la Société
avant la migration, et l’existence de la Société se poursuit après la migration.

IV. que par des résolutions valablement adoptées par (i) l’Associé Unique de la Société le 21 novembre 2014, agissant

conformément aux statuts de la Société et (ii) le conseil d’administration de la Société le 21 novembre 2014, ont dûment
décidé de convertir la Société en une société de droit luxembourgeois, ladite conversion étant effective à la date des
présentes sans dissolution de la Société mais au contraire avec la pleine continuité de sa personnalité juridique. Toutes
les formalités requises en vertu des lois applicables pour donner effet aux présentes résolutions y compris l’adoption de
résolutions nécessaires (à savoir les résolutions de l’Associé Unique et celles du conseil d’administration) aux Iles Caïmans
ont été dûment accomplies. Une copie desdites résolutions restera attachée au présent acte;

V. qu’il résulte (i) d’un bilan intérimaire de la Société au 21 novembre 2014 (le Bilan) et (ii) du certificat de gestion en

date du 21 novembre 2014 (le Certificat de Gestion) que la valeur nette de la Société est estimée à au moins vingt-cinq
mille dollars américains (USD 25.000,-). Une copie du Bilan et du Certificat de Gestion, après avoir été signées ne varietur
par le notaire instrumentant et le mandataire agissant au nom de la partie comparante, resteront annexées au présent
acte et seront soumises avec lui auprès de l’enregistrement;

VI. que l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
(a) transfert du siège social, de l’établissement principal, de l’administration centrale et du lieu de gestion effective de

la Société des Iles Caïmans vers le Grand-Duché de Luxembourg avec effet immédiat à compter de la présente Assemblée,
sans dissolution de la Société mais au contraire avec pleine continuité juridique et morale;

(b) adoption par la Société de la forme juridique d’une société à responsabilité limitée avec pour dénomination sociale

ST August Lux Intermediate Holdco S.à r.l., et acceptation de la nationalité luxembourgeoise découlant du transfert du
siège social, principal établissement, administration centrale et lieu de gestion vers le Grand-Duché de Luxembourg;

(c) approbation du Bilan d’ouverture de la Société à compter de la présente Assemblée et confirmation de la description

et de la cohérence de l’intégralité de l’actif et du passif de la Société et du capital souscrit libéré de la Société;

(d) établissement du capital social et affectation de la prime d’émission, et/ou réserve légale, le cas échéant;
(e) modification et refonte complète des statuts de la Société afin de les rendre conformes aux lois du Grand-Duché

de Luxembourg, de sorte que la Société devienne une société régie par le droit luxembourgeois et soumise à la loi
luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée;

(f) prise d’acte de la démission des actuels administrateurs, de la Société et octroi de décharge et nomination de

nouveaux gérants de la Société;

(g) établissement du siège social de la Société, principal établissement, administration centrale et lieu de gestion effective

au 6D, route de Trèves, L-2633, Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg; et

(h) octroi de pouvoirs.
VII. que l’Assemblée a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Associé Unique décide de transférer le siège social, établissement principal, administration centrale et lieu de gestion

effective de la Société des Iles Caïmans vers le Grand-Duché de Luxembourg, avec effet immédiat, sans dissolution de la
Société mais au contraire avec la pleine continuité de sa personnalité juridique. L’Associé Unique déclare en outre que

187768

L

U X E M B O U R G

toutes les formalités requises en vertu des lois des Iles Caïmans à l’effet de rendre effectif ledit transfert ont été dûment
accomplies.

<i>Deuxième résolution

L’Associé Unique décide que la Société (i) adopte la forme d’une société à responsabilité limitée avec pour dénomi-

nation  sociale  ST  August  Lux  Intermediate  Holdco  S.à  r.l.,  (ii)  accepte  la  nationalité  luxembourgeoise  découlant  du
transfert du siège social, établissement principal, administration centrale et lieu de gestion effective de la Société à Sen-
ningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, et (iii) sera, à partir de la date du présent acte, soumise au droit du Grand-
Duché de Luxembourg.

<i>Troisième résolution

L’Associé Unique décide d’approuver le bilan intérimaire de la Société en date du 21 novembre 2014 attestant que la

valeur de l’actif net de la Société s’élève au moins à la valeur du capital social minimum de la Société.

L’Associé Unique note que la description et le montant de l’intégralité de l’actif et du passif de la Société sont tels

qu’indiqués dans le Bilan précité.

L’Associé Unique atteste que l’intégralité de l’actif et du passif de la Société, sans limitation, reste la propriété exclusive

de la Société, qui continue à détenir tous ses actifs et passifs et continue d’être responsable à l’égard de toutes ses
obligations et engagements.

<i>Quatrième résolution

L’Associé Unique décide (i) d’établir le capital social de la Société à vingt-cinq mille dollars américains (USD 25.000,-)

représenté par vingt-cinq mille (25.000) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un dollar
américain (USD 1.-) chacune, et (ii) d’allouer un montant s’élevant à deux mille cinq cent dollars américains (USD 2.500,-)
au compte de réserve légale de la Société.

<i>Cinquième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, l’Associé Unique décide de modifier et de reformuler complètement

les statuts de la Société afin de les rendre conformes au droit luxembourgeois.

Les statuts reformulés de la Société auront la teneur suivante:

I. Dénomination - Siège social - Objet- Durée

Art. 1 

er

 . Dénomination.  Le nom de la société est «ST August Lux Intermediate Holdco S.à r.l.» (la Société). La Société

est une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du
10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).

Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi à Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans

cette même commune par décision du conseil de gérance. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché
de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger

par une décision du conseil de gérance. Lorsque le conseil de gérance estime que des développements ou événements
extraordinaires d’ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou évé-
nements sont de nature à compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée
entre le siège social et l’étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète
de ces circonstances. Ces mesures provisoires n’ont aucun effet sur la nationalité de la Société, qui, nonobstant le transfert
provisoire de son siège social, reste une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social.
3.1. L’objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans toutes sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut en outre investir, par
souscription, achat et échange ou de toute autre manière dans tous titres, actions et autres valeurs de participation,
obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs mobilières
et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement,
à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. En outre, elle peut investir dans l’acquisition et la gestion d'un
portefeuille de brevets ou autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l’émission de billets à ordre, d’obligations et de tous types de titres et ins-
truments de dette ou de capital. Elle peut prêter des fonds, y compris, sans limitation, les revenus de tous emprunts, à
ses filiales, sociétés affiliées ainsi qu’à toutes autres sociétés. Elle peut également consentir des garanties et nantir, céder,
grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres
obligations et celles de toute autre société, et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou

187769

L

U X E M B O U R G

personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir
obtenu l’autorisation requise.

3.3. La Société peut employer toutes les techniques, moyens juridiques et instruments nécessaires à une gestion efficace

de ses investissements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux
d’intérêt et autres risques.

3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions

concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.

Art. 4. Durée.
4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.
4.2. La Société ne sera pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l’incapacité, de l’insol-

vabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à vingt-cinq mille dollars américains (USD 25.000) représenté par vingt-cinq mille (25.000)

parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un dollar américain (USD 1,-) chacune.

5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée

selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales.
6.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu’un (1) seul propriétaire par part sociale.
6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
6.3. Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.
6.4. Lorsque la Société a plus d’un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l’accord

préalable des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.

6.5. Une cession de parts sociales ne sera opposable à l’égard de la Société ou des tiers qu’après avoir été notifiée à

la Société ou acceptée par celle-ci conformément à l’article 1690 du Code Civil luxembourgeois.

6.6. Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.
6.7. La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition que:
(i) elle ait des réserves distribuables suffisantes à cet effet; ou
(ii) le rachat résulte d’une réduction du capital social de la Société.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Nomination et révocation des gérants.
7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérant(s) nommé(s) par une résolution des associés, qui fixe la durée de

leur mandat. Les gérants ne doivent pas nécessairement être associés.

7.2. Les gérants sont révocables à tout moment, avec ou sans raison, par une décision des associés.

Art. 8. Conseil de gérance. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent le conseil, qui sera composé d’un ou

plusieurs gérant(s) de classe A et un ou plusieurs gérant(s) de classe B (le Conseil).

8.1. Pouvoirs du conseil de gérance
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts aux associés sont de la compétence du

Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l’objet social.

(ii) Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches

spécifiques.

8.2. Procédure
(i) Le Conseil se réunit sur convocation de deux (2) gérants, au lieu indiqué dans l’avis de convocation, qui en principe

sera au Grand-Duché de Luxembourg.

(ii) Il sera donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24)

heures à l’avance, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence seront mentionnées
dans la convocation.

(iii) Aucune convocation n’est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et si chacun d’eux

déclare avoir parfaitement connaissance de l’ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la con-
vocation à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées
pour des réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.

187770

L

U X E M B O U R G

(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés, sous
réserve que si le (les) associé(s) ont nommés un (1) ou plusieurs gérants de classe A et un (1) ou plusieurs gérants de
classe B, au moins un (1) gérant de classe A et un (1) gérant de classe B votent en faveur de ladite résolution. Les décisions
du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun président n’a été
nommé, par tous les gérants présents ou représentés.

(vi) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visio- conférence, ou par tout autre

moyen de communication permettant à l’ensemble des personnes participant à la réunion de s’identifier, de s’entendre
et de se parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement
convoquée et tenue.

(vii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (les Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et

engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d’une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue
et portent la date de la dernière signature.

8.3. Représentation
(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par les signatures conjointes de tout gérant de

classe A et tout gérant de classe B.

(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toute(s) personne(s) à qui des pouvoirs

spéciaux ont été délégués par le Conseil.

Art. 9. Gérant unique. Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil, aux

gérants ou à tout gérant doit être considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.

Art. 10. Responsabilité des gérants. Les gérants ne peuvent être tenus personnellement responsables pour les enga-

gements valablement pris par eux au nom de la Société dans le cadre de leur mandat, dans la mesure où ces engagements
sont conformes aux Statuts et à la Loi.

IV. Associé(s)

Art. 11. Assemblées générales des associés et résolutions écrites des associés.
11.1. Pouvoirs et droits de vote
(i) Sauf lorsque des résolutions sont adoptées conformément à l’article 11.1. (ii), les résolutions des associés sont

adoptées en assemblée générale des associés (chacune une Assemblée Générale).

(ii) Si le nombre des associés de la Société ne dépasse pas vingt-cinq (25), les résolutions des associés peuvent être

adoptées par écrit (des Résolutions Ecrites des Associés).

(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
11.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote
(i) Les associés peuvent être convoqués aux Assemblées Générales à l’initiative du Conseil. Le Conseil doit convoquer

une Assemblée Générale à la demande des associés représentant plus de la moitié du capital social.

(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant

la date de l’assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence sont précisées
dans la convocation à ladite assemblée.

(iii) Si des résolutions sont adoptées par écrit, le Conseil communique le texte des résolutions à tous les associés. Les

associés votent par écrit et envoient leur vote à la Société endéans le délai fixé par le Conseil. Chaque gérant est autorisé
à compter les votes.

(iv) Les Assemblées Générales sont tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.
(v) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et

informés de l’ordre du jour de l’assemblée, l’Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.

(vi) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne (associé ou non) afin de le représenter à

toute Assemblée Générale.

(vii) Les décisions de l’Assemblée Générale sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social.

Si cette majorité n’est pas atteinte à la première Assemblée Générale, les associés sont convoqués par lettre recommandée
à une seconde Assemblée Générale et les décisions sont adoptées par la seconde Assemblée Générale à la majorité des
voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.

(viii) Les Statuts ne peuvent être modifiés qu’avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant

au moins les trois-quarts du capital social.

(ix) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l’engagement d’un associé dans la

Société exige le consentement unanime des associés.

(x) Les Résolutions Ecrites des Associés sont adoptées avec le quorum de présence et de majorité détaillés ci-avant.

Elles porteront la date de la dernière signature reçue endéans le délai fixé par le Conseil.

Art. 12. Associé unique. Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1):

187771

L

U X E M B O U R G

(i) l’associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à l’Assemblée Générale;
(ii) toute référence dans les Statuts aux associés, à l’Assemblée Générale, ou aux Résolutions Ecrites des Associés doit

être considérée, le cas échéant, comme une référence à l’associé unique ou aux résolutions de ce dernier; et

(iii) les résolutions de l’associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle

Art. 13. Exercice social et approbation des comptes annuels.
13.1. L'exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente-et-un (31) décembre de chaque année.
13.2. Chaque année, le Conseil dresse le bilan et les comptes de résultats, ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur des

actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes du ou des
gérants de la Société et des associés envers la Société.

13.3. Tout associé peut prendre connaissance de l’inventaire et du bilan au siège social.
13.4. Le bilan et les comptes de résultats sont approuvés de la manière suivante:
(i) si le nombre d’associés de la Société n’excède pas vingt-cinq (25), dans les six (6) mois suivant la clôture de l’exercice

social concerné, soit (a) lors de l’Assemblée Générale annuelle (si elle est tenue), soit (b) par voie de Résolutions Ecrites
des Associés; ou

(ii) si le nombre d’associés de la Société excède vingt-cinq (25), lors de l’Assemblée Générale annuelle.
13.5. Si le nombre d’associés de la Société excède vingt-cinq (25), l’Assemblée Générale annuelle se tient à l’adresse

du siège social ou en tout autre lieu dans la municipalité du siège social, comme indiqué dans la convocation, le deuxième
lundi du mois de mai de chaque année à 10 heures. Si ce jour n’est pas un jour ouvré au Grand-Duché de Luxembourg,
l’Assemblée Générale annuelle se tient le jour ouvré suivant.

Art. 14. Réviseurs d'entreprises/Commissaires.
14.1 Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés, dans les cas prévus

par la loi. Les associés nomment les réviseurs d'entreprises, s'il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur rémunération
et la durée de leur mandat.

14.2. Si le nombre d’associés de la Société excède vingt-cinq (25), les opérations de la Société sont contrôlées par un

ou plusieurs commissaires, sauf si la loi exige la nomination d’un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés. Les com-
missaires peuvent être réélus par l’Assemblée Générale annuelle. Ils ne doivent pas nécessairement être associés.

Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi (la

Réserve Légale). Cette affectation cesse d'être exigée quand la Réserve Légale atteint dix pour cent (10 %) du capital
social.

15.2. Les associés décident de l’affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au

paiement d'un dividende, l’affecter à un compte de réserve ou le reporter en respectant les dispositions légales applicables.

15.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;
(ii) ces comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves (y compris la prime d'émission) suffisants

sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant des bénéfices
réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant, augmenté
des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter à la
Réserve Légale;

(iii) la décision de distribuer des dividendes intérimaires doit être adoptée par le Conseil dans les deux (2) mois suivant

la date des comptes intérimaires; et

(iv) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société;
Si les dividendes intérimaires qui ont été distribués dépassent les bénéfices distribuables à la fin de l’exercice social, le

Conseil a le droit de réclamer la répétition des dividendes ne correspondant pas à des bénéfices réellement réalisés et
les associés doivent immédiatement reverser l’excès à la Société à la demande du Conseil.

VI. Dissolution - Liquidation

16.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la majorité (en nombre)

des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social. Les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs, qui
n'ont pas besoin d'être associés, pour réaliser la liquidation et déterminent leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf
décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer
les dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes, le cas échéant, est distribué aux

associés proportionnellement aux parts sociales détenues par chacun d'entre eux.

187772

L

U X E M B O U R G

VII. Dispositions générales

17.1. Les convocations et communications, respectivement les renonciations à celles-ci, sont faites, et les Résolutions

Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Ecrites des Associés sont établies par écrit, téléfax, e-mail ou tout autre
moyen de communication électronique.

17.2. Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du

Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.

17.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions

légales pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants, des
résolutions adoptées par le Conseil par téléphone ou visioconférence et des Résolutions Ecrites des Associés, selon le
cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique
document.

17.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi applicable et, sous

réserve des dispositions légales d'ordre public, à tout accord conclu de temps à autre entre les associés.

<i>Sixième résolution

L’Associé Unique décide de prendre acte de la démission, avec effet à la date des présentes, des administrateurs en

fonction avant le transfert du siège social, du principal établissement, de l’administration centrale et du lieu de gestion de
la Société des Iles Caïmans vers le Grand-Duché de Luxembourg de leurs fonction d’administrateurs de la Société et leur
accorde pleine décharge pour l’exercice de leurs fonctions à partir de la date de leur nomination en tant qu’administrateurs
de la Société jusqu’à la date de leur démission.

L’Associé Unique décide en outre de nommer les personnes suivantes en qualité de gérants de la Société pour une

durée indéterminée:

<i>Gérants de Classe A:

- Jim KIRSLIS, né au Massachusetts, Etats-Unis d’Amérique le 9 mars 1962, avec adresse au 4 King Phillip Circle,

Rockland, MA 02370, Etats-Unis d’Amérique; et

- Geert BRAAKSMA, né à Oostdongeradeel, Pays-Bas, le 2 juillet 1957, avec adresse à Vechtlaan 62, 7555 JZ Hengelo,

Pays-Bas.

<i>Gérants de Classe B:

- Dylan DAVIES, né à Swansea, Royaume-Uni, le 16 novembre 1966, avec adresse à 6D, route de Trèves, L-2633

Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg; et

- Cedric BRADFER, né à Chambery, France, le 2 août 1978, avec adresse à 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg,

Grand-Duché de Luxembourg.

<i>Septième résolution

L’Associé Unique décide d’établir le siège social, le principal établissement, l’administration centrale et le lieu de gestion

effective de la Société au 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg.

<i>Huitième résolution

L’Associé Unique décide de nommer tout gérant de Classe B de la Société nouvellement nommé, en tant que man-

dataire autorisé pour accomplir au Grand-Duché de Luxembourg tous les actes et formalités en lien avec la migration
réalisée par la Société de son siège social, principal d’établissement, administration centrale et lieu de gestion effective
des Iles Caïmans vers le Grand-Duché de Luxembourg, notamment l’immatriculation de la Société au Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg et signer et accomplir tout autre document et acte qui peuvent être utiles ou
nécessaires relatifs à ladite migration.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la demande de la partie comparante, le présent acte

est rédigé en anglais, suivi d’une version française, et en cas de divergences, le texte anglais prévaut.

Le présent acte notarié est passé à Echternach, à la date qu’en tête des présentes.
Après avoir lu l’acte à voix haute, le notaire le signe avec le mandataire de l’Associé Unique.
Signé: P. SIMON, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 25 novembre 2014. Relation: ECH/2014/2260. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 28 novembre 2014.

Référence de publication: 2014191510/662.
(140212666) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 décembre 2014.

187773

L

U X E M B O U R G

SRE Waterloo Holding Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 12.000,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 151.420.

In the year two thousand and fourteen, on the thirty-first day of October.
Before Maître Francis Kesseler, notary established in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

SRE Portfolios UK Ltd, a limited liability company existing under the laws of England, having its registered office at 4

Thomas More Square, London E1W 1YW, United Kingdom, and with company number 07833099 (the “Sole Sharehol-
der”),

hereby duly represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, notary clerk, with professional address at 5, rue Zénon

Bernard, L-4030 Esch Sur Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

Such proxy having been signed “ne varietur” by the proxy-holder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, shall remain attached to this deed to be filed with it with the registration authorities.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record as follows:
I.- The appearing party is the sole shareholder of SRE Waterloo Holding S.à r.l., a Luxembourg private limited liability

company  (société  à  responsabilité  limitée)  having  its  registered  office  at  25A,  boulevard  Royal,  L-2449  Luxembourg,
incorporated by a deed enacted by Me Carlo Wersandt, notary established in Luxembourg, on 12 February 2010, pu-
blished in the Luxembourg official gazette (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations) (the "Mémorial") number
671 on 30 March 2010, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 151.420
(the “Company”).

The articles of association of the Company have been lastly amended by a notarial deed enacted by the undersigned

notary dated 12 July 2013, published in the Mémorial number 2352 on 24 September 2013.

II.- That the 90,968 (ninety thousand nine hundred sixty-eight) ordinary shares with a nominal value of GBP 30 (thirty

British Pounds) each, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can
validly decide on all the items of the agenda of which the Sole Shareholder expressly states having been duly informed
beforehand.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1. Waiving of notice right;
2. Decrease of the share capital of the Company by an amount of GBP 2,717,040 (two million seven hundred seventeen

thousand forty British Pounds) so as to decrease it from its current amount of GBP 2,729,040 (two million seven hundred
twenty-nine thousand forty British Pounds) to GBP 12,000 (twelve thousand British Pounds) by the cancellation of 90,568
(ninety thousand five hundred sixty-eight) shares with a nominal value of GBP 30 (thirty British Pounds) each, and allocation
of the nominal value of the capital decrease to the distributable reserve of the Company;

3. Subsequent amendment of article 8, paragraph 1 of the articles of association of the Company; and
4. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolutions have been taken:

<i>First resolution:

It is resolved that the Sole Shareholder waives its right to the prior notice of the current meeting, acknowledges being

sufficiently informed on the agenda, considers being validly convened and therefore agrees to deliberate and vote upon
all the items of the agenda. It is further resolved that all the relevant documentation has been put at the disposal of the
Sole Shareholder within a sufficient period of time in order to allow it to examine carefully each document.

<i>Second resolution:

It is resolved to decrease the share capital of the Company by an amount of GBP 2,717,040 (two million seven hundred

seventeen thousand forty British Pounds) so as to decrease it from its current amount of GBP 2,729,040 (two million
seven hundred twenty-nine thousand forty British Pounds) to GBP 12,000 (twelve thousand British Pounds) by the can-
cellation of 90,568 (ninety thousand five hundred sixty-eight shares with a nominal value of GBP 30 (thirty British Pounds)
each (the “Capital Decrease”), and to allocate the nominal value of the Capital Decrease to the distributable reserve of
the Company (the “Allocation”).

<i>Third resolution:

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, it is resolved to amend article 8, paragraph 1 of the

Company’s articles of association so as to read as follows:

187774

L

U X E M B O U R G

“The Company's share capital is set at GBP 12,000 (twelve thousand British Pounds), represented by 400 (four hun-

dred) shares with a nominal value of GBP 30 (thirty British Pounds) each.”

No other amendment is to be made to this article.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon closed.

Whereof  the  present  notarial  deed  was  drawn  up  in  Esch-sur-Alzette  on  the  day  named  at  the  beginning  of  this

document.

The document having been read to the proxy-holder of the person appearing, such proxy-holder of the person ap-

pearing signed together with us, the notary, the present original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la version française du texte qui précède

L'An deux mille quatorze, le trente-et-unième jour d'octobre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire établi à Esch-sur-Alzette, Grand Duché du Luxembourg.

A comparu:

SRE Portfolios UK Ltd, une société à responsabilité limitée constituée selon les lois de l’Angleterre, ayant son siège

social sis au 4 Thomas More Square, Londres E1W 1YW, Royaume-Uni, ayant pour numéro de société 07833099 (l’"As-
socié Unique").

ici représentée par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, clerc de notaire, avec adresse professionnelle au 5, rue Zénon

Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand Duché de Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration ayant été paraphée «ne varietur» par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante

et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités de l’en-
registrement.

La partie comparante, représentée tel que décrit ci-dessus, a requis du notaire soussigné d’acter ce qui suit:
I.- La partie comparante est l’associé unique de SRE Waterloo Holding S.à.r.l., une société à responsabilité limitée

constituée selon le droit luxembourgeois, ayant son siège social sis au 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, con-
stituée selon un acte reçu par Me Carlo Wersandt, notaire établi à Luxembourg, le 12 février 2010, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial") numéro 671, le 30 mars 2010, immatriculée auprès du Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 151.420 (la "Société").

Les statuts de la Société ont été dernièrement modifiés par un acte passé devant le notaire soussigné en date du 12

juillet 2013, publié au Mémorial, numéro 2352, le 24 septembre 2013.

II.- Les 90.968 (quatre-vingt-dix mille neuf cent soixante-huit) parts sociales de la Société ayant une valeur nominale

de 30 GBP (trente Livres Sterling) chacune, représentant la totalité du capital social de la Société, sont représentées de
sorte que l’assemblée peut valablement se prononcer sur tous les points de l’ordre du jour sur lesquels l’Associé Unique
reconnaît expressément avoir été dûment et préalablement informé.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. Renonciation au droit de convocation;
2. Réduction du capital social de la Société par un montant de 2.717.040 GBP (deux millions sept cent dix-sept mille

quarante Livres Sterling) afin de le porter de son montant actuel de 2.729.040 GBP (deux million sept cent vingt-neuf
mille quarante Livres Sterling à 12.000 GBP (douze mille Livres Sterling) par l’annulation de 90.568 (quatre-vingt-dix mille
cinq cent soixante-huit) parts sociales d’une valeur nominale de 30 GBP (trente Livres Sterling) chacune, et allocation de
la valeur nominale de la réduction du capital à la réserve distribuable de la Société;

3. Modification subséquente de l’article 8 alinéa 1 des statuts de la Société; et
4. Divers.
Suite à l’approbation de ce qui précède par l’Associé Unique, les résolutions suivantes ont été adoptées:

<i>Première résolution:

Il est décidé que l’Associé Unique renonce à son droit de convocation préalable à la présente assemblée, reconnaît

avoir été suffisamment informé de l’ordre du jour et considère avoir été valablement convoqué et en conséquence accepte
de délibérer et de voter sur tous les points portés à l’ordre du jour. Il est en outre décidé que l’ensemble de la docu-
mentation produite lors de l’assemblée a été mise à la disposition de l’Associé Unique dans un laps de temps suffisant afin
de lui permettre un examen attentif de chaque document.

187775

L

U X E M B O U R G

<i>Seconde résolution:

Il est décidé de diminuer le capital social de la Société par un montant de 2.717.040 GBP (deux millions sept cent dix-

sept mille quarante Livres Sterling) afin de le porter de son montant actuel de 2.729.040 GBP (deux million sept cent
vingt-neuf mille quarante Livres Sterling britanniques) à 12.000 GBP (douze mille Livres Sterling britanniques) par l’annu-
lation de 90.568 (quatre-vingt-dix mille cinq cent soixante-huit) parts sociales d’une valeur nominale de 30 GBP (trente
Livres Sterling chacune (la "Réduction du Capital"), et d'allouer la valeur nominale de la Réduction du Capital à la réserve
distribuable de la Société (l’ "Allocation").

<i>Troisième résolution:

En conséquence des résolutions et déclarations qui précèdent, il est décidé de modifier l’article 8 alinéa 1 des statuts

de la Société pour lui donner la teneur suivante:

“Le capital social de la Société est fixé à 12.000 GBP (douze mille Livres Sterling britanniques), représenté par 400

(quatre cent) parts sociales d’une valeur nominale de 30 GBP (trente Livres Sterling) chacune.”

Pas d'autre modification de cet article n'a été effectuée.
Aucun autre point n’ayant été soulevé, l’assemblée a été ajournée.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, au jour indiqué en tête du présent document.
Lecture ayant été faite de ce document au mandataire de la personne comparante, ce dernier a signé avec nous, notaire,

l’original du présent acte.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que, sur demande de la personne présente à l’assemblée,

le présent acte est établi en anglais suivi d’une traduction en français. Sur demande de la même personne présente, et en
cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.

Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 06 novembre 2014. Relation: EAC/2014/14999. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2014191508/134.
(140212537) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 décembre 2014.

Revetas Holding LX 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 182.637.

EXTRAIT

En date du 1 

er

 décembre 2014, l'associé unique a pris la résolution suivante:

1) La démission de M. Alan Botfield en tant que gérant de la Société est acceptée avec effet au 15 octobre 2014

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2014192104/12.
(140213666) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

3B4Sports S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 164.018.

Il y a dorénavant lieu de prendre en compte l'adresse professionnelle de Monsieur Wolfgang Streit, administrateur de

classe B de la Société, située au 2 Grafenauweg, P.O. Box 4442, 6304 Zug, Suisse.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 novembre 2014.

Jana Oleksy / Daphné Charbonnet
<i>Administrateur de classe A / Administrateur de classe A

Référence de publication: 2014192251/13.
(140213619) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

187776


Document Outline

3B4Sports S.A.

C2B Group S.à r.l.

Capital Européen S.A.

Captalents Development S.A.

Captalents Development S.A.

Carnet S.A.

Carnet S.A.

CB Lux S.à r.l.-FIS

Celebrating

CF Consulting S.à r.l.

Chamaeleon S.à r.l.

Chamaeleon S.à r.l.

CHH France 1 S.A.

CII, Luxembourg Branch

Cilix Investments S.A.

CKYAD. M. Transport

Clairam S.A.

Colors Capital Companies

Compagnie d'Investissement du Sud S.A.

Compagnie Financière Terria S.A.

Compas S.A.

Comptabilité Thill Susi Sàrl

Craven Properties S.à r.l.

CRF2T S.à r.l.

CT Real Estate

Cuni-Fuels S.A.

Dazzle Luxembourg N° 2 S.A.

Dazzle Luxembourg N° 3 S.A.

DB Vita

Defoe Holding S.à r.l.

Delling Holding S.à r.l.

Demaison S.A.

Demsec S.A.

Deutsche Zinshaus Lux S.à r.l.

Dream Global 26 S.à r.l.

D-R Luxembourg Holding 1

Food Delivery Holding 5 S.à r.l.

Revetas Holding LX 1 S.à r.l.

SRE Waterloo Holding Sàrl

St August Lux Intermediate Holdco S.à r.l.

VCP VII Luxco 6 S.à r.l.

Ventura Investors S.A.

Vicaro S.A.

Vittoria Sport

Voltana Investments S.à r.l.