This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 3829
11 décembre 2014
SOMMAIRE
AIM SOFTWARE Luxembourg S.A. . . . . .
183792
Andreus Properties S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
183792
Broadstreet International Partners S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
183748
Broadstreet of Münsbach S.à r.l. . . . . . . . . .
183747
CHH Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
183785
Classifieds Azerbaijan S.C.Sp . . . . . . . . . . . .
183756
E.RE.A.S. Finance S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
183757
Financière Figaro II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
183755
Fox Bar S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
183752
Garage Schneiders s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
183752
Greganna Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
183778
Günter Mencher Soparfi S.à r.l. . . . . . . . . . .
183752
HellermannTyton Beta S.à r.l. . . . . . . . . . . .
183751
Highland VII - PRI (2) S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
183752
Hydrus Luxco 2 S.à r.l . . . . . . . . . . . . . . . . . .
183763
Ihr Schreiner S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
183746
Immo Préitzerdaul S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . .
183746
Islazul Joint Venture S.à.r.l . . . . . . . . . . . . . .
183790
ITXC IP Holdings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
183753
Januaship Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
183753
La Gardenia Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
183755
LK Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
183748
L.M.I. Reconstruction Luxembourg . . . . . .
183749
Lumex Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
183755
MERCURY TECHNOLOGIES . . . . . . . . . . .
183748
Meubles d'Exception s.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
183754
Meyer Bergman European Retail Partners
I Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
183751
M & H Capital Management S.A., société
de gestion de patrimoine familial, en
abrégé SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
183754
Morisco International S.A. . . . . . . . . . . . . . .
183754
Oil Field Partners S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
183749
Oxford Street Capital 2 S.à r.l. . . . . . . . . . .
183751
Passage s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
183746
Passage s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
183747
Privin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
183753
Privin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
183754
ProLogis UK IV S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
183749
Ragtime Investissements S.A. . . . . . . . . . . .
183750
Ravensbourne Ventures S.à r.l. . . . . . . . . . .
183748
Ravensbourne Ventures S.à r.l. . . . . . . . . . .
183749
Red Anchor Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
183750
Rolebased Solutions S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
183750
Schneiders Finance SA . . . . . . . . . . . . . . . . .
183747
Serafim Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
183746
Serafim Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
183746
SHCO 99 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
183790
SM Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
183747
Springboard Finance Holdco S.à r.l. . . . . . .
183753
Steel Invest & Finance (Luxembourg) S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
183760
183745
L
U X E M B O U R G
Ihr Schreiner S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5441 Remerschen, 39, route du Vin.
R.C.S. Luxembourg B 149.759.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014188365/10.
(140211095) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2014.
Immo Préitzerdaul S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8615 Platen, 29, Beim Kinnebesch.
R.C.S. Luxembourg B 94.573.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014188366/10.
(140210632) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2014.
Serafim Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 83.697.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27/11/2014.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2014188608/11.
(140211079) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2014.
Serafim Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 83.697.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27/11/2014.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2014188609/11.
(140211080) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2014.
Passage s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9660 Insenborn, 1, Bonnal.
R.C.S. Luxembourg B 98.431.
Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Insenborn, le 27 novembre 2014.
Signature
<i>Le Géranti>
Référence de publication: 2014188528/12.
(140211026) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2014.
183746
L
U X E M B O U R G
SM Holdings S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R.C.S. Luxembourg B 49.107.
Les comptes annuels au 30 JUIN 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Référence de publication: 2014188620/10.
(140210707) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2014.
Schneiders Finance SA, Société Anonyme.
Siège social: L-6450 Echternach, 17, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 96.308.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 27 novembre 2014.
Signature.
Référence de publication: 2014188605/10.
(140210792) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2014.
Passage s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9660 Insenborn, 1, Bonnal.
R.C.S. Luxembourg B 98.431.
Le bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Insenborn, le 27 novembre 2014.
Signature
<i>Le Géranti>
Référence de publication: 2014188529/12.
(140211027) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2014.
Broadstreet of Münsbach S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 473.888.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 90.780.
Il résulte des résolutions écrites de l'associé unique de la Société en date du 29 octobre 2014 que:
- Madame Lisa Wadlin a démissionné de son mandat de gérante de catégorie A de la Société avec effet au 1
er
novembre
2014.
- Il est décidé de nommer en remplacement de Madame Lisa Wadlin, Monsieur Kenneth Goldberg, né le 21 juillet 1963
à New Jersey, Etats-Unis d'Amérique, résidant professionnellement au 702 S.W. 8
th
Street, Bentonville, AR 72716, Etats-
Unis d'Amérique, comme gérant de catégorie A de la Société avec effet au 1
er
novembre 2014 pour une durée
indéterminée.
Par conséquent, le conseil de gérance est maintenant composé comme suit:
- Kenneth Goldberg, comme gérant de catégorie A de la Société;
- Stéphane Reul, comme gérant de catégorie B de la Société; et
- Antoine Berckmans, comme gérant de catégorie B de la Société.
Le 26 novembre 2014.
Pour extrait conforme
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2014187410/22.
(140210371) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2014.
183747
L
U X E M B O U R G
MERCURY TECHNOLOGIES, Société Anonyme de Titrisation.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 168.778.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 novembre 2014.
Référence de publication: 2014188459/10.
(140210921) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2014.
LK Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 84.631.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 novembre 2014.
Référence de publication: 2014188394/10.
(140211321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2014.
Ravensbourne Ventures S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 159.526.
Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 novembre 2014.
Manacor (Luxembourg) S.A.
Signatures
<i>Géranti>
Référence de publication: 2014188557/14.
(140210802) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2014.
Broadstreet International Partners S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 2.305.304.560,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 144.415.
Il résulte des résolutions écrites des associés de la Société en date du 29 octobre 2014 que:
- Madame Lisa Wadlin a démissionné de son mandat de gérante A de la Société avec effet au 1
er
novembre 2014.
- Il est décidé de nommer en remplacement de Madame Lisa Wadlin, Monsieur Kenneth Goldberg, né le 21 juillet 1963
à New Jersey, Etats-Unis d'Amérique, résidant professionnellement au 702 S.W. 8
th
Street, Bentonville, AR 72716, Etats-
Unis d'Amérique, comme gérant A de la Société avec effet au 1
er
novembre 2014 pour une durée indéterminée.
Par conséquent, le conseil de gérance est maintenant composé comme suit:
- Kenneth Goldberg, comme gérant A de la Société;
- Stéphane Reul, comme gérant B de la Société; et
- Antoine Berckmans, comme gérant B de la Société.
Le 26 novembre 2014.
Pour extrait conforme
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2014187411/20.
(140210369) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2014.
183748
L
U X E M B O U R G
Oil Field Partners S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 139.228.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 20 novembre 2014.
Référence de publication: 2014188495/10.
(140211276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2014.
L.M.I. Reconstruction Luxembourg, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1320 Luxembourg, 90, rue de Cessange.
R.C.S. Luxembourg B 126.543.
Les comptes annuels clos au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014188395/10.
(140210784) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2014.
Ravensbourne Ventures S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 159.526.
Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 novembre 2014.
Manacor (Luxembourg) S.A.
Signatures
<i>Géranti>
Référence de publication: 2014188558/14.
(140210812) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2014.
ProLogis UK IV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 69.901.
à inscrire: Suite à un contrat daté du 25 novembre 2014, soixante-dix-sept mille cinq cents (77,500) parts sociales
détenues dans la Société, Prologis UK Holding VI BV ont étés transférées à Prologis Holding XI (A) BV ayant son siège
social à Gustav Mahlerplein 17, 1082 MS Amsterdam, The Netherlands. Cette cession des parts sociales a été approuvée
au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.
A faire paraître dans l'Extrait:
Répartitions des parts sociales:
Prologis Holding XI (A) BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77,500 parts
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77,500 parts sociales
Luxembourg, le 25 novembre 2014.
ProLogis Directorship Sàrl
<i>Gérant
i>Représenté par Gerrit Jan Meerkerk
<i>Géranti>
Référence de publication: 2014187827/20.
(140209758) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2014.
183749
L
U X E M B O U R G
Rolebased Solutions S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 84.144.
Les comptes au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
ROLEBASED SOLUTIONS S.A.
Régis DONATI / Alexis DE BERNARDI
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2014188575/12.
(140211024) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2014.
Ragtime Investissements S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 132.148.
<i>Extrait du Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 11 novembre 2014i>
Démission de Monsieur Frédéric Mannis en tant qu'administrateur de la Société et ce, avec effet immédiat.
Cooptation de Madame Maria Dos Santos née le 22 août 1976 à Metz (France), demeurant professionnellement au
20, boulevard Emmanuel Servais L-2535 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Frédéric Mannis, administrateur
démissionnaire.
Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.
Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale annuelle.
POUR EXTRAIT SINCERE ET CONFORME
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2014187871/16.
(140209675) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2014.
Red Anchor Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: JPY 1.800.000,00.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 191.400.
EXTRAIT
Il résulte d'un contrat de transfert de parts sociales signé en date du 13 Octobre 2014 que CVC Capital Partners Asia
IV Limited, associé unique de la Société a transféré toutes ses un million huit cent mille (1.800.000) parts sociales détenues
dans la Société comme indiqué ci-dessous:
- un million six cent cinquante mille quatre cent quatre-vingt-dix (1.650.490) parts sociales à CVC Capital Partners
Asia Pacific IV L.P., une société immatriculée au "Jersey Financial Services Commission" sous le numéro 1708, ayant son
siège social au Lime Grove House, Green Street, St Helier, Jersey JE1 2ST;
- cinquante et un mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept (51.497) parts sociales détenues dans la Société à CVC Capital
Partners Asia Pacific IV (J) L.P., une société immatriculée au "Jersey Financial Services Commission" sous le numéro 1767,
ayant son siège social au Lime Grove House, Green Street, St Helier, Jersey JE1 2ST;
- quatre-vingt-quatre mille neuf cent soixante et onze (84.971) parts sociales détenues dans la Société à CVC Capital
Partners Investment Asia IV L.P., une société immatriculée au "Jersey Financial Services Commission" sous le numéro
1775, ayant son siège social au Lime Grove House, Green Street, St Helier, Jersey JE1 2ST; et
- treize mille quarante-deux (13.042) parts sociales détenues dans la Société à CVC Capital Partners Asia IV Associates
L.P., une société immatriculée au "Jersey Financial Services Commission" sous le numéro 1742, ayant son siège social au
Lime Grove House, Green Street, St Helier, Jersey JE1 2ST.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 novembre 2014.
Référence de publication: 2014187862/26.
(140210441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2014.
183750
L
U X E M B O U R G
Meyer Bergman European Retail Partners I Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 136.239.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions des associés prises en date du 26 novembre 2014 que:
- Monsieur Donatien-Xavier Martin, né le 20 février 1986 à Malmedy (Belgique), résidant professionnellement au 412F,
route d'Esch L-1030 Luxembourg, est nommé gérant B de la société pour une durée indéterminée, en remplacement de
Laëtitia Jolivalt, gérante B démissionnaire.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 Novembre 2014.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2014187736/17.
(140210291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2014.
Oxford Street Capital 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 171.460.
<i>Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 25 novembre 2014i>
1. M. Douwe TERPSTRA a démissionné de son mandat de gérant B.
2. Monsieur Frank PLETSCH, administrateur de sociétés, né à Trier (Germany), le 15 juillet 1974, demeurant profes-
sionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, gérant de catégorie B, a été nommé comme gérant B pour
une durée indéterminée.
Veuillez noter que l'adresse professionnelle de Monsieur Mark GORHOLT et Monsieur Vincent COINTEPAS, gérants
B, se situe désormais au L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
Luxembourg, le 25 novembre 2014.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour Oxford Street Capital 2 S.à r.l.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2014187799/18.
(140210100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2014.
HellermannTyton Beta S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 30.764.750,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 113.276.
Par résolutions signées en date du 12 novembre 2014, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Nomination de Gérard Becquer, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au
mandat de gérant, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée;
2. Nomination d'Emilie Morette, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au
mandat de gérant, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée;
3. Acceptation de la démission de Fabian Sires, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Lu-
xembourg de son mandat de gérant, avec effet immédiat;
4. Acceptation de la démission d'Alexis Roux, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxem-
bourg de son mandat de gérant, avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 novembre 2014.
Référence de publication: 2014187613/19.
(140210520) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2014.
183751
L
U X E M B O U R G
Günter Mencher Soparfi S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5440 Remerschen, 34, Waïstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 136.728.
Der Jahresabschluss vom 31/12/2009 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014188332/9.
(140211241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2014.
Garage Schneiders s.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-6450 Echternach, 17, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 99.430.
Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 27 novembre 2014.
Signature.
Référence de publication: 2014188317/10.
(140210796) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2014.
Fox Bar S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3512 Dudelange, 229, rue de la Libération.
R.C.S. Luxembourg B 174.933.
EXTRAIT
Il résulte d'une assemblée générale extraordinaire du 26 novembre 2014.
L'assemblée révoque avec effet rétroactif au 15 novembre 2014:
- Madame Alexandra Luisa MARTINS PAULO, demeurant à F-57390 Audun-le-Tiche, 76, Rue de la Meuse, de sa
fonction de gérant technique.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dudelange, le 26 novembre 2014.
FOX BAR SARL
Signature
Référence de publication: 2014187588/16.
(140210491) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2014.
Highland VII - PRI (2) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 346.041,00.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 146.561.
EXTRAIT
Il résulte des décisions prises par l'Associé Unique de la Société en date du 31 octobre 2014:
1. La démission de Monsieur Philippe SALPETIER gérant de classe B a été acceptée avec effet au 31 octobre 2014.
2. Les personnes suivantes ont été nommées gérants de classe B, avec effet au 31 octobre 2014 et ce pour une durée
indéterminée:
- Monsieur Livio GAMBARDELLA, né le 2 décembre 1975 à Terlizzi, Italie et demeurant professionnellement au 16,
avenue Pasteur L-2310 Luxembourg;
- Madame Corine CHATY, née le 20 mai 1970 à Metz, France et demeurant professionnellement au 16 avenue Pasteur,
L-2310 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 novembre 2014.
Référence de publication: 2014187617/19.
(140210503) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2014.
183752
L
U X E M B O U R G
ITXC IP Holdings, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 100.682.
Les comptes annuels au 31 mars 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014188375/10.
(140211207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2014.
Januaship Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 144.127.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Référence de publication: 2014188378/10.
(140211028) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2014.
Privin S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1461 Luxembourg, 27, rue d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 64.488.
Le bilan au 31.12.2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 novembre 2014.
Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L – 1013 Luxembourg
Référence de publication: 2014188541/14.
(140211017) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2014.
Springboard Finance Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 50.000,00.
Siège social: L-2165 Luxembourg, 23-29, Rives de Clausen.
R.C.S. Luxembourg B 149.196.
<i>Extrait des résolutions écrites prises par l'associé unique de la Société en date du 19 novembre 2014i>
En date du 19 novembre 2014, l'associé unique de la Société a pris la résolution de nommer Monsieur Lauri PAAL, né
le 13 juillet 1976 à Tallinn, Estonie, résidant professionnellement à l'adresse suivante: 23-29, Rives de Clausen, L-2165
Luxembourg en tant que nouveau gérant de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.
Le conseil de gérance de la Société est désormais composé comme suit:
- Monsieur Lauri PAAL
- Monsieur Benjamin Owen ORNDORFF
- Monsieur Keith Ranger DOLLIVER
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 novembre 2014.
Springboard Finance Holdco S.àr.l.
Signature
Référence de publication: 2014187917/20.
(140209946) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2014.
183753
L
U X E M B O U R G
Meubles d'Exception s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8606 Bettborn, 65-69, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 172.124.
Le bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2014188461/10.
(140211047) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2014.
Morisco International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach.
R.C.S. Luxembourg B 86.606.
Le Bilan au 31 DECEMBRE 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Référence de publication: 2014188465/10.
(140210669) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2014.
Privin S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1461 Luxembourg, 27, rue d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 64.488.
Le bilan au 31.12.2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 novembre 2014.
Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L – 1013 Luxembourg
Référence de publication: 2014188542/14.
(140211184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2014.
M & H Capital Management S.A., société de gestion de patrimoine familial, en abrégé SPF, Société Ano-
nyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 142.567.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 10 novembre 2014 que:
- Le mandat d'administrateur de Monsieur Marek WOLOS, économiste, né à Parczew (Pologne) le 7 juin 1976, de-
meurant à ul. Stanislawa Barei 1 m. 76, 03-141 Varsovie (Pologne), a été confirmé avec effet au 8 septembre 2014.
- Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale annuelle de 2019.
- Gestman S.A. a démissionné de son poste de commissaire.
- A été nommée au poste de Commissaire en remplacement du commissaire démissionnaire:
* Gestal Sàrl, immatriculée au RCS de Luxembourg sous le numéro B 184722 avec siège social au 23, rue Aldringen -
L-1118 Luxembourg.
- Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale annuelle de 2019.
Luxembourg.
Pour extrait sincère et conforme
Référence de publication: 2014187715/20.
(140209753) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2014.
183754
L
U X E M B O U R G
Financière Figaro II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 3.000.000,00.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 24, avenue Emile Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 155.694.
Le siège social de l'associé unique de la Société, AXA Secondary Fund IV L.P. a été transféré de 22, Grenville Street,
St. Helier, Jersey, Channel Islands, JE48PX à 4
th
Floor, Northern Suite, Channel House, Green Street, St. Helier, Jersey,
Channel Islands, JE2 4UH.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014187562/12.
(140210341) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2014.
La Gardenia Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 184.446.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil tenue le 25/11/2014.i>
<i>Résolution:i>
Le conseil coopte Mme Virginie Derains, avec adresse professionnelle au 31 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
L-1331 Luxembourg, en tant que nouveau gérant,en remplacement de Mme Sonia Laraba, démissionnaire.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 25/11/2014.
Référence de publication: 2014187686/14.
(140209779) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2014.
Lumex Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 167.572.
- Constituée en date du 14 mars 2012 suivant acte reçu par Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à L-
Luxembourg, publié au Mémorial Recueil Spécial C n° 1072 du 26 avril 2012.
En date du 03 décembre 2012:
- La propriété de 200 parts sociales de valeur nominale 100,00 euros chacune a été transférée par l'associé GALWAY
FOUNDATION avec siège social à Edificio Capital Plaza, piso 15, Paseo Roberto Motta, Costa del Este, PANAMA,
République du Panama, à Monsieur Mariano GANDUXER FLORIACH demeurant à Margenat, 97, E-08017 Barcelona;
- La propriété de 200 parts sociales de valeur nominale 100,00 euros chacune a été transférée par l'associé DERBEND
FOUNDATION avec siège social à Edificio Capital Plaza, piso 15, Paseo Roberto Motta, Costa del Este, PANAMA,
République du Panama, à Monsieur Mariano GANDUXER FLORIACH demeurant à Margenat, 97, E-08017 Barcelona;
- La propriété de 200 parts sociales de valeur nominale 100,00 euros chacune a été transférée par l'associé FRADES
FOUNDATION avec siège social à Edificio Capital Plaza, piso 15, Paseo Roberto Motta, Costa del Este, PANAMA,
République du Panama, à Monsieur Mariano GANDUXER FLORIACH demeurant à Margenat, 97, E-08017 Barcelona;
- La propriété de 200 parts sociales de valeur nominale 100,00 euros chacune a été transférée par l'associé ORCADAS
FOUNDATION avec siège social à Edificio Capital Plaza, piso 15, Paseo Roberto Motta, Costa del Este, PANAMA,
République du Panama, à Monsieur Mariano GANDUXER FLORIACH demeurant à Margenat, 97, E-08017 Barcelona;
- La propriété de 200 parts sociales de valeur nominale 100,00 euros chacune a été transférée par l'associé PEIPUS
FOUNDATION avec siège social à Edificio Capital Plaza, piso 15, Paseo Roberto Motta, Costa del Este, PANAMA,
République du Panama, à Monsieur Mariano GANDUXER FLORIACH demeurant à Margenat, 97, E-08017 Barcelona.
Luxembourg, le 25 novembre 2014.
<i>Pour la société LUMEX S.A R.L.
i>FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Référence de publication: 2014187711/28.
(140210244) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2014.
183755
L
U X E M B O U R G
Classifieds Azerbaijan S.C.Sp, Société en Commandite spéciale.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 192.103.
<i>Excerpts of the limited partnership agreement (the “Limited Partnership Agreement”) of Classifieds Azerbaijan S.C.SP, a speciali>
<i>limited partnership, executed on 21 November 2014i>
1. Partners who are jointly and severally liable. Digital Services XXVII (GP) S.à r.l., a société à responsabilité limitée
incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 5, Heienhaff,
L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register
under number B 188568 (the “General Partner”).
2. Name, Partnership’s Purpose, Registered Office, Business Year.
(i) Name
The special limited partnership shall have the name: Classifieds Azerbaijan S.C.SP (the “Partnership”).
(ii) Purpose
The purpose of the Partnership is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign
companies, limited partnerships or other arrangements and in any other form of investment, the acquisition by purchase,
subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and
the administration, management, control and development of its portfolio in order to further the development, marketing
and provision of internet services through such foreign subsidiaries (ecommerce covering goods and services of different
kinds) and the provision of logistic services, digital services and all other services relating to the aforementioned business.
The Partnership may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds
a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the Partnership.
The Partnership is entitled to pursue any and all activities which directly or indirectly serve its purpose. The Partnership
exercises any and all rights and obligations which pertain to any shares or interests in other companies.
(iii) Registered Office
The Partnership shall have its registered office at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
(iv) Business Year
The business year of the Partnership shall be the calendar year.
3. Designation of the manager and signatory powers. The management of the Partnership is incumbent upon the
General Partner.
The General Partner shall manage the Partnership on the basis of the provisions of the Partnership Agreement and
otherwise in the best interest of the Partnership. Any liability of the General Partner vis-à-vis the Partnership or its
Partners shall be limited to willful misconduct (dol) and gross negligence (négligence grave).
The Partnership is validly bound vis-à-vis third parties by the signature of the General Partner that represents it.
4. Date on which the Partnership commences and the date on which it ends. The Partnership commences as from 21
November 2014, for an indefinite term.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:
<i>Auszüge aus dem Gesellschaftsvertrag (dem „Limited Partnership Agreement“) der Classifieds Azerbaijan S.C.SP, einer Partner-i>
<i>schaftsgesellschaft nach Luxemburgischen Recht (Special Limited Partnership), geschlossen am 21 November 2014i>
1. Gesellschafter, die unmittelbar und gesamtschuldnerisch haften. Digital Services XXVII (GP) S.à.r.l., eine Gesellschaft
mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), welche den Bestimmungen des Gesetzes des Großherzogtums
Luxemburg unterliegt, mit Geschäftssitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen
im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) unter der Nummer B
188568 (die „Komplementärin“).
2. Name, Zweck der Gesellschaft, Sitz, Geschäftsjahr.
(i) Name
Die Gesellschaft heißt: Classifieds Azerbaijan S.C.SP (die „Gesellschaft“)
(ii) Zweck der Gesellschaft
Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Gesell-
schaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder
auf andere Weise sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form, die Verwaltung, Kontrolle und
Entwicklung ihrer Beteiligungen im Hinblick auf die Entwicklung, das Marketing und die Erbringung von Internetdienst-
leistungen durch ausländische Tochtergesellschaften (im Bereich ECommerce bezüglich Waren und Dienstleistungen
183756
L
U X E M B O U R G
jeglicher Art) sowie die Erbringung von Logistikdienstleistungen, Digitaldienstleistungen und allen anderen Dienstleistun-
gen, die mit der zuvor genannten Geschäftstätigkeit im Zusammenhang stehen.
Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, an denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder
Rechte jeglicher Art hält oder die der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören, Garantien geben, Sicher-
heiten einräumen, Darlehen gewähren oder die Gesellschaften auf jede andere Weise unterstützen.
Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten ausüben, die direkt oder indirekt ihrem Zweck dienen.
Die Gesellschaft kann jegliche Rechte und Pflichten in Bezug auf Beteiligungen an anderen Gesellschaften ausüben.
(iii) Sitz
Der Sitz der Gesellschaft ist in der rue 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
(iv) Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr wird das Kalenderjahr sein.
3. Wahl des Geschäftsführers und Zeichnungsbefugnisse. Die Geschäftsführung der Gesellschaft obliegt der amtie-
renden Komplementärin.
Die Komplementärin wird die Gesellschaft auf Basis der Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages oder in sonstiger
Weise bestmöglich im Interesse der Gesellschaft führen. Jede Haftung der Komplementärin gegenüber der Gesellschaft
wird auf Fälle des Vorsatzes (dol) und der groben Fahrlässigkeit (négligence grave) beschränkt.
Die Gesellschaft wird durch die Unterschrift der Komplementärin, durch welche die Gesellschaft repräsentiert wird,
rechtskräftig gegenüber Dritten verpflichtet.
4. Anfang und Enddatum der Gesellschaft. Die Gesellschaft wird am 21 November 2014 für eine unbegrenzte Dauer
gegründet.
Référence de publication: 2014187457/76.
(140210090) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2014.
E.RE.A.S. Finance S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 158.472.
In the year two thousand and fourteen, the twenty-fourth day of October.
Before Us, Maître Cosita DELVAUX, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held
an extraordinary general meeting of the shareholders (the Meeting) of “E.RE.A.S. FINANCE S.C.A.”, a corporate
partnership limited by shares (société en commandite par actions), having its registered office at 20, rue de la Poste,
L-2346 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Com-
panies under number B 158472 (the Company).
The Company has been incorporated pursuant to a deed of Maître Paul BETTINGEN, notary residing in Niederanven,
dated January 12, 2011 and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, under number 822 on
April 27, 2011. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended for the last time pursuant
to a deed of Maître Paul BETTINGEN prenamed on September 7, 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, under number 2502 on October 9, 2012.
The Meeting is chaired by Thomas DEWE, employee, residing professionally in Luxembourg.
The chairman appoints Francesco GUARNIERI, employee, residing professionally in Luxembourg as secretary of the
Meeting.
The Meeting elects Dario PUCCINELLI, employee, residing professionally in Luxembourg as scrutineer of the Meeting.
The chairman, the secretary and the scrutineer are collectively referred to hereafter as the Bureau of the Meeting.
The Bureau of the Meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state that:
I. The shareholders present or represented at the Meeting (the Shareholders) and the number of shares they hold are
indicated on an attendance list, which will remain attached to the present deed after having been signed ne varietur by
the representative(s) of the Shareholders, the undersigned notary and the members of the Bureau of the Meeting (the
Attendance List). The powers of attorney of the Shareholders that are represented at the Meeting, after signature ne
varietur by the proxyholder(s) will also remain attached to the present deed.
II. As appears from the Attendance List, 121 ordinary shares out of 789 ordinary shares and 1 management share are
present or represented at the present Meeting. A first meeting with the same agenda has been convened but didn’t reach
the requested quorum. The second and present meeting has been convened with the same agenda. The Meeting can
therefore validly decide on all the items of the agenda which has previously been communicated to the Shareholders,
each of them expressly declaring to acknowledge the agenda.
III. The agenda of the Meeting is worded as follows:
183757
L
U X E M B O U R G
1. Waiver of the convening notice.
2. Acceptance of the resignation of E.RE.A.S. MANAGEMENT S.à r.l. in its capacity as General Partner (referred to as
the “Manager”), with effect as at July 30, 2014.
3. Full and definitive discharge.
4. Appointment of Y.K.L Holding S.A. as new General Partner (referred to as the “Manager”), with effect as at July 30,
2014.
5. Amendment of article 11 of the articles of association.
6. Miscellaneous.
IV. After the agenda was duly examined and after deliberations, the Meeting has unanimously resolved the following:
<i>First resolutioni>
The meeting resolves not to waive the convening notices.
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolves to accept the resignation of E.RE.A.S. MANAGEMENT S.à r.l. as General Partner (the “Manager”)
of the company, with effect as at July 30, 2014.
<i>Third resolutioni>
The Meeting resolves to grand full and definitive discharge to the said General Partner.
<i>Fourth resolutioni>
The Meeting resolves to appoint as new General Partner (the “Manager”) of the Company, with effect as at July 30,
2014 and for an unlimited period of time:
Y.K.L Holding S.A., a company with registered office at 4, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg (RCS Luxembourg B
189865)
<i>Fifth resolutioni>
The Meeting resolves to amend the article 11, first paragraph of the articles of association of the Company, which shall
henceforth be read as follows:
“ Art. 11. first paragraph. The Company shall be managed by Y.K.L Holding S.A. (herein referred to as the “Manager”).”
There being no further business, the meeting is closed.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately EUR 2,000.-.
<i>Declarationsi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the Bureau of the Meeting, said Bureau of the Meeting signed together with us,
the notary, the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille quatorze, le vingt-quatre octobre.
Par-devant Nous, Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est tenue
une assemblée générale extraordinaire des associés (l’Assemblée) de “E.RE.A.S. FINANCE S.C.A.”, une société en
commandite par actions dont le siège social est situé au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 158472 (la
Société).
La Société a été constituée suivant acte de Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven daté du 12
janvier 2011 et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 822 le 27 avril 2011. Les statuts
de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte de Maître Paul BETTINGEN prénommé
en date du 7 septembre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 2502 le 9
octobre 2012.
L'Assemblée est présidée par Thomas DEWE, employé, dont la résidence professionnelle se situe à Luxembourg.
183758
L
U X E M B O U R G
Le président désigne Francesco GUARNIERI, employé, dont la résidence professionnelle se situe à Luxembourg, en
tant que secrétaire de l’Assemblée.
L'Assemblée nomme Dario PUCCINELLI employé, dont la résidence professionnelle se situe à Luxembourg, en tant
que scrutateur de l’Assemblée.
Le président, le secrétaire et le scrutateur sont désignés ci-après dans leur ensemble comme le Bureau de l’Assemblée.
Le Bureau de l’Assemblée ayant été ainsi constitué, le président déclare et prie le notaire d’acter que:
I. Les associés présents ou représentés à l’Assemblée (les Associés) ainsi que le nombre d’actions qu'ils détiennent
figurent sur une liste de présence, qui restera annexée au présent acte après avoir été signée ne varietur par le ou les
mandataires des Associés, le notaire instrumentant et les membres du Bureau de l’Assemblée (la Liste de Présence). Les
procurations des Associés représentés à l’Assemblée, après signature ne varietur par le ou les mandataires resteront
également annexées au présent acte.
II. Ainsi qu'il ressort de la Liste de Présence, 121 actions ordinaires des 789 actions ordinaires et une action de
commandité sont présentes ou représentées à la présente Assemblée. Une première assemblée avec le même ordre du
jour a été convoquée mais sans attendre le quorum requis. La deuxième et présente assemblée a été convoquée avec le
même ordre du jour. L’Assemblée peut par conséquent valablement délibérer sur tous les points de l’ordre du jour qui
ont été préalablement communiqués aux Associés, chacun d’eux déclarant expressément reconnaître l’ordre du jour.
III. L'ordre du jour de l’Assemblée est libellé de la manière suivante:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Acceptation de la démission de E.RE.A.S. MANAGEMENT S.à r.l. de sa fonction de Gérant Commandité (qualifié
«le Gérant») de la société, avec effet au 30 juillet 2014;
3. Décharge complète et définitive;
4. Nomination de Y.K.L Holding S.A. en qualité de nouveau Gérant Commandité (qualifié «le Gérant») de la société,
avec effet au 30 juillet 2014;
5. Modification de l’article 11 des statuts;
6. Divers.
IV. Après examen de l’agenda et après délibération, l’Assemblée décide de prendre à l’unanimité les résolutions sui-
vantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de ne pas renoncer aux formalités de convocation.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide d’accepter la démission de E.RE.A.S. MANAGEMENT S.à r.l. de ses fonctions de Gérant Com-
mandité de la société («le Gérant»), avec effet au 30 juillet 2014.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée décide de donner décharge totale et définitive au Gérant Commandité.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée décide de nommer en qualité de nouveau Gérant Commandité de la société («le Gérant»), avec effet au
30 juillet 2014 et pour une durée indéterminée:
Y.K.L Holding S.A., une société ayant son siège au 4, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg (RCS Luxembourg B 189865).
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée décide de modifier l’article 11 alinéa 1
er
des statuts de la soci8 des statuts de la Société, qui aura désormais
la teneur suivante:
« Art. 11. alinéa 1
er
. La société est gérée par Y.K.L Holding S.A. (dans cet acte «le Gérant»).»
Aucun autre point n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée est levée.
<i>Estimation des fraisi>
Les dépenses, coûts, rémunérations et charges de quelque nature que ce soit qui incomberont à la Société du fait du
présent acte sont estimés à approximativement EUR 2.000,-.
<i>Déclarationsi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare ici que sur demande des parties comparantes ci-dessus, le
présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, à la demande des mêmes parties comparantes,
en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
183759
L
U X E M B O U R G
Après lecture du présent acte au Bureau de l’Assemblée, ledit Bureau de l’Assemblée a signé avec nous, le notaire, le
présent acte original.
Signé: T. DEWE, F. GUARNIERI, D. PUCCINELLI, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 30 octobre 2014. Relation: LAC/2014/50649. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 novembre 2014.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2014183332/146.
(140206844) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2014.
Steel Invest & Finance (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8011 Strassen, 283, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 82.516.
In the year two thousand fourteen,
on the thirty-first day of the month of October.
Before Us Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in SANEM, Grand Duchy of Luxembourg,
was held
an Extraordinary General Meeting of shareholders (the “Meeting”) of “Steel Invest & Finance (Luxembourg) S.A." (the
“Company”), a société anonyme established and having its registered office at 283, route d’Arlon, L-8011 Strassen, in-
corporated pursuant to a notarial deed enacted on 08 June 2001, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations (the “Mémorial”) number 1192 of 19 December 2001.
The Articles of Incorporation of the Company were amended pursuant to several notarial deeds and for the last time
by a notarial deed enacted on 30 November 2011, published in the Mémorial, on 27 January 2012, under number 235
and page 11273.
The Meeting was opened by Mr Alain PEIGNEUX, chartered accountant, residing professionally at 283, route d’Arlon,
L-8011 Strassen being in the chair,
who appointed as secretary Mrs Bénédicte GRANDMAISON, employee, residing professionally at 283, route d’Arlon,
L-8011 Strassen
The Meeting elected as scrutineer Mrs Catherine DRISSENS, employee, residing professionally at 283, route d’Arlon,
L-8011 Strassen.
The board of the Meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the Meeting is the following:
1. Increase of capital in the amount of ONE HUNDRED MILLION EUROS (EUR 100,000,000.-) to raise it from its
present amount of FIVE HUNDRED FORTY-ONE MILLION EIGHT HUNDRED SEVENTY-TWO THOUSAND ONE
HUNDRED FIFTY EURO (EUR 541,872,150.-) to SIX HUNDRED FORTY-ONE MILLION EIGHT HUNDRED SEVEN-
TY-TWO THOUSAND ONE HUNDRED FIFTY EUROS (EUR 641,872,150.-) by creation and issue of TWO MILLION
(2,000,000) new shares with a par value of FIFTY EUROS (EUR 50.-) each, to be issued at par and benefiting of the same
rights and advantages as the presently issued shares. The increase in the capital will be carried out through a contribution
in kind for an amount of ONE HUNDRED MILLION EUROS (EUR 100,000,000.-).
2. Subscription of the TWO MILLION (2,000,000) new shares by LLC "NLMK Overseas Holdings", incorporated and
existing under the laws of Russian Federation and with registered office at 2, Metallurgov sq., Lipetsk, 398040, Russia.
3. Acknowledgment of waiver of preferential subscription right in connection with the present capital increase.
4. Amendment of article 5 of the Articles of Association in order to reflect the above resolutions.
5. Miscellaneous.
II. The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed “ne varietur” by the shareholders, the proxy-
holders of the represented shareholders, the board of the Meeting and the undersigned notary, will remain annexed to
the present deed and shall be filed at the same time with the registration authorities.
The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present
Meeting, so that the Meeting is regularly constituted and can validly decide on all the items of the agenda.
After the foregoing has been approved by the Meeting, the same unanimously took each time, by unanimous vote, the
following resolutions:
183760
L
U X E M B O U R G
<i>First resolutioni>
The Meeting RESOLVES to increase the subscribed capital by an amount of ONE HUNDRED MILLION EUROS (EUR
100,000,000.-) in order to raise it from its current amount of FIVE HUNDRED FORTY-ONE MILLION EIGHT HUN-
DRED SEVENTY-TWO THOUSAND ONE HUNDRED FIFTY EURO (EUR 541,872,150.-) to an amount of SIX
HUNDRED FORTY- ONE MILLION EIGHT HUNDRED SEVENTY-TWO THOUSAND ONE HUNDRED FIFTY EU-
ROS (EUR 641,872,150.-) by the creation and issue of TWO MILLION (2,000,000) new ordinary shares with a par value
of FIFTY EUROS (EUR 50.-) each, to be issued at par and benefiting of the same rights and advantages as the presently
issued shares.
<i>Second resolutioni>
The Meeting, after having acknowledged, that the current shareholder “NLMK INTERNATIONAL B.V., a company
incorporated and existing under the laws of the Netherlands and with registered office at Strawinskylaan 1331, 1077 XX
Amsterdam, has waived to the extent necessary its preferential subscription rights in connection with the present capital
increase, RESOLVES to accept the subscription and full payment of the newly issued shares by the other current share-
holder, LLC "NLMK Overseas Holdings", incorporated and existing under the laws of Russian Federation and with
registered office at 2, Metallurgov sq., Lipetsk, 398040, Russia (the “Subscriber”),
here represented by Mr Alain PEIGNEUX, prenamed,
by virtue of a proxy given in Lipetsk (Russia) on 28 October 2014,
which proxy, after been signed “ne varietur” by the proxyholder, by the members of the Board of the Meeting and by
the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for registration purposes.
Said proxyholder, in said capacity, declares to subscribe, in the name and on behalf of the Subscriber, the TWO
MILLION (2,000,000) new issued shares and to fully pay them up by irrevocable waiver of its unquestionable and imme-
diately payable claims against the Company, the claim being waived up to ONE HUNDRED MILLION EUROS (EUR
100,000,000.-) (the “Contribution”).
Proof of the ownership by the Subscriber “LLC "NLMK Overseas Holdings" of the Contribution has been validly given
to the undersigned notary, who expressly states this.
Which Contribution in kind was subject to a special report drawn up by a “reviseur d’entreprises” the limited company
"Osiris Enterprise, 02E, Public Accountants”, established and having its registered office at L-8011 Strassen, 283, route
d’Arlon, on 30 October 2014;
which report drawn up in accordance with article 26-1 in connexion with article 32-1 (5) of the law of 10 August 1915
on commercial companies, as amended, concludes that:
“Based on the work performed and described above, nothing has come to our attention that causes us to believe that
the value of the Receivable to be contributed does not correspond at least to the value of the share capital to be issued.”.
Said report, after been signed “ne varietur”, by all the appearing persons and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed for registration purposes.
<i>Third resolutioni>
The Meeting RESOLVES to amend article 5, first paragraph of the articles of association of the Company in order to
reflect the above resolutions, which will henceforth have the following new wording:
“ Art. 5. (first paragraph). The corporate capital is set at SIX HUNDRED FORTY-ONE MILLION EIGHT HUNDRED
SEVENTY-TWO THOUSAND ONE HUNDRED FIFTY EURO (EUR 641,872,150.-) represented by twelve million eight
hundred thirty-seven thousand four hundred and forty-three (12,837,443) shares with a par value of FIFTY EURO (EUR
50.-) each.”
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately six thousand three hundred euro.
There being no further business, the Meeting is thereupon closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF the present deed was drawn up in Strassen, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the members of the board of the Meeting and to the appearing parties, who are
known to the notary by their surname, first name, civil status and residence, they signed together with Us the notary the
present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille quatorze,
183761
L
U X E M B O U R G
le trente et un octobre.
Par devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est réunie
l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l’«Assemblée») de «Steel Invest & Finance (Luxembourg) S.A.» (la
«Société»), une société anonyme établie et ayant son siège social au 283, route d’Arlon, L-8011 Strassen, constituée par
acte notarié en date du 08 juin 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro
1192 du 19 décembre 2001.
Les statuts de la Société furent modifiés par plusieurs actes notariés et pour la dernière fois suivant acte notarié dressé
en date du 30 novembre 2011, publié au Mémorial en date du 27 janvier 2012, sous le numéro 235 et page 11273.
L'Assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Alain PEIGNEUX, expert-comptable, avec adresse profes-
sionnelle au 283, route d’Arlon, L-8011 Strassen,
qui désigne comme secrétaire Madame Bénédicte GRANDMAISON, employée privée, avec adresse professionnelle
au 283, route d’Arlon, L-8011 Strassen.
L'Assemblée choisit comme scrutatrice Madame Catherine DRISSENS, employée privée, avec adresse professionnelle
au 283, route d’Arlon, L-8011 Strassen.
Le bureau de l’Assemblée ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I. Que la présente Assemblée a pour ordre du jour:
1. Augmentation du capital social à concurrence de CENT MILLIONS D’EUROS (EUR 100'000’000.-) en vue de le
porter de son montant actuel de CINQ CENT QUARANTE ET UN MILLIONS HUIT CENT SOIXANTE-DOUZE MILLE
CENT CINQUANTE EUROS (EUR 541'872'150.-) à SIX CENT QUARANTE ET UN MILLIONS HUIT CENT SOIXAN-
TE-DOUZE MILLE CENT CINQUANTE EUROS (EUR 641'872'150.-) par la création et l’émission de DEUX MILLIONS
(2'000’000) actions nouvelles d’une valeur nominale de CINQUANTE EUROS (EUR 50.-) chacune, émises au pair et
jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes. L’augmentation de capital se fera par un apport nature
d’un montant de CENT MILLIONS D’EUROS (EUR 100'000'000.-).
2. Souscription des DEUX MILLIONS (2.000.000) actions nouvelles par LLC "NLMK Overseas Holdings", constituée
sous et régie par les lois de la Fédération de Russie et ayant son siège social à 2, Metallurgov sq., Lipetsk, 398040, Russie.
3. Renonciation du droit de souscription préférentiel par rapport à la présente augmentation de capital.
4. Modification de l’article 5 des statuts en vue de refléter les résolutions ci-dessus.
5. Divers.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne
varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
de l’Assemblée et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la
formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés.
III. Qu'il appert de la liste de présence que toutes les actions en circulation sont présentes ou dûment représentées à
la présente Assemblée, laquelle est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée,
sur les points portés à l’ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’Assemblée, celle-ci prend chaque fois, à l’unanimité des voix les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée DECIDE d’augmenter le capital social d’un montant de CENT MILLIONS D'EUROS (EUR 100'000'000.-)
en vue de le porter de son montant actuel de CINQ CENT QUARANTE ET UN MILLIONS HUIT CENT SOIXANTE-
DOUZE MILLE CENT CINQUANTE EUROS (EUR 541'872'150.-) à un montant de SIX CENT QUARANTE ET UN
MILLIONS HUIT CENT SOIXANTE DOUZE MILLE CENT CINQUANTE EUROS (EUR 641'872'150.-) par la création
et l’émission de DEUX MILLIONS (2.000.000) actions ordinaires nouvelles d’une valeur nominale de CINQUANTE EU-
ROS (EUR 50.-) chacune, émises au pair et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée, après avoir constaté que l’actionnaire existant, «NLMK INTERNATIONAL BV», une société constituée
sous et régie par les lois des Pays-Bas et ayant son siège social à Strawinskylaan 1331, 1077 XX Amsterdam, Pays-Bas, a
renoncé, dans la mesure nécessaire, à l’exercice de son droit de souscription préférentiel, DECIDE d’accepter la sou-
scription et la libération intégrale des actions nouvellement émises, par l’autre actionnaire existant, LLC "NLMK Overseas
Holdings", constituée sous et régie par les lois de la Fédération de Russie et ayant son siège social à 2, Metallurgov sq.,
Lipetsk, 398040, Russie (le «Souscripteur»),
ici représentée par Monsieur Alain PEIGNEUX, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Lipetsk (Russie) le 28 octobre 2014,
183762
L
U X E M B O U R G
laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire, les membres du bureau de l’Assemblée
et par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Lequel mandataire, agissant ès-dites qualités, a déclaré souscrire, au nom et pour le compte du Souscripteur, les DEUX
MILLIONS (2'000'000) actions nouvelles et les libérer entièrement par la conversion de créances certaines, liquides et
exigibles qu'elle détient sur la Société, à concurrence de CENT MILLIONS EUROS (EUR 100'000'000.-) (l’«Apport»).
La preuve par LLC "NLMK Overseas Holdings" de la propriété de l’Apport a été rapportée au notaire soussigné, qui
la reconnaît expressément.
Lequel Apport a fait l’objet d'un rapport établi préalablement aux présentes par le réviseur d'entreprises, la société
anonyme «Osiris Enterprise, 02E, Public Accountants», établie et ayant son siège social à L-8011 Strassen,, 283, route
d’Arlon, en date du 30 octobre 2014.
Lequel rapport établi conformément à l’article 26-1 en connexion avec l’article 32-1 (5) de la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée par la suite, conclut en langue anglaise que:
“Based on the work performed and described above, nothing has come to our attention that causes us to believe that
the value of the Receivable to be contributed does not correspond at least to the value of the share capital to be issued.”.
Ledit rapport, après avoir été signé «ne varietur» par toutes les personnes comparantes et le notaire soussigné,
demeurera annexé au présent acte avec lequel il sera soumis à la formalité du timbre et de l’enregistrement.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée DECIDE de modifier l’article 5, premier alinéa des statuts de la Société afin de refléter les résolutions ci-
dessus, pour lui donner la nouvelle teneur suivante:
« Art. 5. (premier alinéa). Le capital social est fixé à SIX CENT QUARANTE ET UN MILLIONS HUIT CENT SOIXAN-
TE-DOUZE MILLE CENT CINQUANTE EUROS (EUR 641'872'150.-), représenté par douze millions huit cent trente-
sept mille quatre cent quarante-trois (12'837'443) actions ordinaires d’une valeur nominale de CINQUANTE EUROS
(EUR 50.-) chacune.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
à raison de la présente est évalué à environ six mille trois cents euros.
Plus rien n'étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire instrumentaire, qui comprend et parle anglais, reconnaît qu'à la requête des personnes comparantes ci-
dessus, le présent acte a été rédigé en anglais, suivi d'une version française, et qu'à la requête des mêmes personnes
comparantes et en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, fait et passé à Strassen, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux membres du bureau de l’Assemblée et aux comparants, connus du notaire par leurs noms,
prénoms usuels, états et demeures, ceux-ci ont signé avec Nous le notaire le présent acte.
Signé: A. PEIGNEUX, B. GRANDMAISON, C. DRISSENS, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 05 novembre 2014. Relation: EAC/2014/14904. Reçu soixante-quinze Euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveur ff.i>
(signé): Monique HALSDORF.
Référence de publication: 2014179450/194.
(140205917) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2014.
Hydrus Luxco 2 S.à r.l, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 192.075.
STATUTES
In the year two thousand and fourteen, on the eighteenth day of November.
Before us, Maître Edouard DELOSCH, notary residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg
THERE APPEARED:
Firewall Hydrus TopCo, S.A., a public limited liability company (société anonyme), incorporated and governed by the
laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at Boulevard de la Foire 1, L-1528 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of thirty one thousand euro (EUR 31,000.-), and registered with the
Luxembourg Company and Trade Register under number B 191623
here represented by Julia Szafranska, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Luxembourg,
on 17 November 2014.
183763
L
U X E M B O U R G
The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed
to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing parties have requested the officiating notary to enact the deed of incorporation of a private limited
company (société à responsabilité limitée) which they wish to incorporate with the following articles of association:
A. Name - Purpose - Duration - Registered office
Art. 1. Name - Legal Form. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name
Hydrus Luxco 2 S.à r.l. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning
commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.
Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign
companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio.
2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it
holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the
Company.
2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by
issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.
2.4 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities
which it considers useful for the accomplishment of these purposes.
Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of
managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution
of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution
of the board of managers.
4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances
or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
traordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwiths-
tanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.
B. Share capital - Shares
Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), represented by twelve
thousand five hundred (12,500) (the “Shares”) shares themselves subdivided into:
(a) one thousand two hundred fifty (1,250) series 1 redeemable shares having a par value of one euro (EUR 1.-) each
(the “Tranche 1 Shares”);
(b) one thousand two hundred fifty (1,250) series 2 redeemable shares having a par value of one euro (EUR 1.-) each
(the “Tranche 2 Shares”);
(c) one thousand two hundred fifty (1,250) series 3 redeemable shares having a par value of one euro (EUR 1.-) each
(the “Tranche 3 Shares”);
(d) one thousand two hundred fifty (1,250) series 4 redeemable shares having a par value of one euro (EUR 1.-) each
(the “Tranche 4 Shares”);
(e) one thousand two hundred fifty (1,250) series 5 redeemable shares having a par value of one euro (EUR 1.-) each
(the “Tranche 5 Shares”);
(f) one thousand two hundred fifty (1,250) series 6 redeemable shares having a par value of one euro (EUR 1.-) each
(the “Tranche 6 Shares”);
(g) one thousand two hundred fifty (1,250) series 7 redeemable shares having a par value of one euro (EUR 1.-) each
(the “Tranche 7 Shares”);
183764
L
U X E M B O U R G
(h) one thousand two hundred fifty (1,250) series 8 redeemable shares having a par value of one euro (EUR 1.-) each
(the “Tranche 8 Shares”);
(i) one thousand two hundred fifty (1,250) series 9 redeemable shares having a par value of one euro (EUR 1.-) each
(the “Tranche 9 Shares”); and
(j) one thousand two hundred fifty (1,250) series 10 redeemable shares having a par value of one euro (EUR 1.-) each
(the “Tranche 10 Shares” and together with Tranche 1 Shares, Tranche 2 Shares, Tranche 3 Shares, Tranche 4 Shares,
Tranche 5 Shares, Tranche 6 Shares, Tranche 7 Shares, Tranche 8 Shares and Tranche 9 Shares, the “Tranches” and
individually the “Tranche”)
5.2 The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
5.3 Any new shares to be paid for in cash shall be offered by preference to the existing shareholder(s) within the same
Tranche. In case of plurality of shareholders, such shares shall be offered to the shareholders in proportion to the number
of shares held in each Tranche held by them in the Company’s share capital. The board of managers shall determine the
period of time during which such preferential subscription right may be exercised and which may not be less than thirty
(30) days from the date of dispatch of a registered letter sent to the shareholder(s) announcing the opening of the
subscription period. The general meeting of shareholders may limit or suppress the preferential subscription right of the
existing shareholder(s) in the manner required for an amendment of these articles of association.
Art. 6. Shares.
6.1 The Company’s share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of
the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.
6.5 No Shares in a particular Tranche may be converted into Shares in a different Tranche.
6.6 The Shares are redeemable shares in the sense of article 49-8 of the Law. Any redemption is subject to the following
conditions:
- only fully paid up shares may be redeemed;
- the conditions set out in articles 6.7 to 6.15 of these articles of association are respected;
- the redemption can only be made by using sums available for distribution in accordance with Article 72-1 of the Law
or the proceeds of a new issue made for the purpose of such redemption;
- an amount equal to the nominal value, or, in the absence thereof, the par value, of all the Shares redeemed must be
included in a reserve which cannot be distributed to the shareholders except in the event of a capital reduction of the
share capital; such reserve may only be used to increase the issued share capital by capitalisation of reserves (such reserve
is not required in case of a redemption using the proceeds of a new issue made with a view to carry out such redemption);
and
- the redemption is published in accordance with the Law
6.7 The share capital of the Company may be reduced through the cancellation of a Tranche, in whole but not in part,
consisting of the repurchase and cancellation of all Shares in issue in such Tranche as may be determined from time to
time by the board of managers.
6.8 The relevant Tranche shall be repurchased and cancelled for an aggregate price equal to the fair market value of
such Tranche (the “Total Cancellation Amount”) as defined in 6.9 below.
6.9 In the event of a reduction of share capital through the repurchase and the cancellation of a Tranche (in the order
provided for in article 6.14.), such Tranche gives right to the holders thereof pro rata to their holding in such Tranche
to the Available Amount (as defined below) and the holders of Shares of the repurchased and cancelled Tranche shall
receive from the Company an amount equal to the Cancellation Value Per Share (as defined below) for each Share of the
relevant Tranche held by them and cancelled.
6.10 The Cancellation Value Per Share shall be calculated by dividing the Total Cancellation Amount (as defined below)
by the number of Shares in issue in the Tranche of Shares to be repurchased and cancelled.
6.11 The Total Cancellation Amount shall be an amount determined by the board of managers on the basis of the
relevant interim accounts of the Company as of a date not earlier than eight (8) days before the date of the repurchase
and cancellation of the relevant Tranche. The Total Cancellation Amount for each Tranche shall be the Available Amount
(increased by the nominal value per share to be cancelled) of the relevant Tranche at the time of the cancellation of the
relevant Tranche unless otherwise resolved by the board of managers provided however that the Total Cancellation
Amount shall never be higher than such Available Amount (increased by the nominal value per share to be cancelled).
The board of managers can choose to include or exclude in its determination of the Total Cancellation Amount, the
freely distributable share or assimilated premium either in part or in totality.
6.12 The Available Amount shall be (i) the total amount of net profits of the Company (including carried forward
profits) increased by (i) any freely distributable reserves and (ii) as the case may be by the amount of the share premium
183765
L
U X E M B O U R G
or assimilated premium and legal reserve reduction relating to the relevant Tranche to be cancelled, but reduced by (i)
any losses (included carried forward losses), (ii) any sums to be placed into undistributable reserve(s) pursuant to the
requirements of law or of these articles of association, each time as set out in the relevant interim accounts and (iii) any
accrued and unpaid dividends to the extent those have not already reduced the NP (without for the avoidance of doubt,
any double counting) (ii) to the extent that the holders of Shares of the relevant Tranche would have been entitled to
dividend distributions according to article 22 of these articles of association, so that: AA = (NP + P+ CR) - (L + LR +
LD). Whereby: AA= Available Amount; NP= net profits (including carried forward profits); P= any freely distributable
reserves; CR = the amount of the share premium reduction and legal reserve reduction relating to the Tranche to be
cancelled; L= losses (including carried forward losses); LR = any sums to be placed into undistributable reserve(s) pursuant
to the requirements of law or of these articles of association; LD = any accrued and unpaid dividends to the extent those
have not already reduced the NP.
6.13 Upon the repurchase and cancellation of the Shares of the relevant Tranche, the Cancellation Value Per Share
will become due and payable by the Company.
6.14 The Shares shall be repurchased in the reverse alphanumerical order of the Tranche, starting with the Tranche
10 Shares.
6.15 Subsequent Shares of a specific Tranche shall only become available for repurchase once all the Shares of the
preceding Tranche have been repurchased in full. Each share of a Tranche becoming available for repurchase according
to the rule specified in this article 7 shall be referred to as the “Relevant Shares”.
Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection
by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.
7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall
appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.
7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given
by the shareholders at a majority of three quarters of the share capital.
7.5 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of
the transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.
7.6 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject
to the approval of such transfer given by the surviving shareholders representing three quarters of the rights owned by
the surviving shareholders. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents,
descendants or the surviving spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.
C. Decisions of the shareholders
Art. 8. Collective decisions of the shareholders.
8.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles
of association.
8.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
8.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise
conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case,
each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his
vote in writing.
8.4 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of
shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by
the sole shareholder.
Art. 9. General meetings of shareholders. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, at least
one general meeting of shareholders shall be held within six (6) months of the end of each financial year in Luxembourg
at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the convening notice of such meeting.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices
of meeting. If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived
any convening requirement, the meeting may be held without prior notice or publication.
Art. 10. Quorum and vote.
10.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
183766
L
U X E M B O U R G
10.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company’s
shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share
capital. If this majority is not reached in a first meeting or proposed written resolution, the shareholders may be convened
a second time with the same agenda or receive such proposed written resolution a second time by registered letter,
decisions are validly adopted in so far as they are adopted by a majority of the votes validly cast whichever is the fraction
of the share capital represented.
Art. 11. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.
Art. 12. Amendments of the articles of association. Any amendment of the articles of association requires the approval
of (i) a majority of shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.
D. Management
Art. 13. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
13.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers
form a board of managers.
13.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not
expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of
association is to be construed as a reference to the “sole manager”.
13.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any
actions necessary or useful to fulfil the Company’s corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the
Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.
13.4 The Company grants a power of attorney to EPIC I GP S.à r.l., a private limited liability company (société à
responsabilité limitée), incorporated and exiting under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered
address at Boulevard de la Foire 1, L-1528 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with Luxembourg
Company and Trade Register under number B186222 (the “Proxyholder”), acting individually and with full power of
substitution, to act on behalf of and represent the Company, itself acting individually or by a power of attorney as the
case may be, at any shareholders or interest holders’ meeting or resolution in writing of any company, corporation,
partnership or any other entity and/or any subsidiary thereof in which the Company holds directly or indirectly shares,
interests or any other participation in respect of (and only in this respect) (i) the appointment or dismissal of directors,
managers or other members of any managing, governing and/or supervisory body for which the Company is entitled to
vote (ii) the amendment of the articles, partnership agreement or bylaws, as the case may be, with respect to the ap-
pointment or dismissal of directors, managers or other members of any managing, governing and/or supervisory body
for which the Company is entitled to vote.
Art. 14. Appointment, removal and term of office of managers.
14.1 The manager(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remune-
ration and term of office and according to article 13.4.
14.2 The managers shall be appointed and may be removed from office at any time, with or without cause, by a decision
of the shareholders representing more than half of the Company’s share capital.
Art. 15. Vacancy in the office of a manager.
15.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or
otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the replaced manager by the remaining managers until the next meeting of shareholders which shall resolve on the
permanent appointment, in compliance with the applicable legal provisions and article 13.4.
15.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company’s sole manager, such vacancy must be filled without undue
delay by the general meeting of shareholders.
Art. 16. Convening meetings of the board of managers.
16.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held
at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.
16.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four (24) hours at
least in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document
being sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location
determined in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.
16.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive
any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of
managers.
183767
L
U X E M B O U R G
Art. 17. Conduct of meetings of the board of managers.
17.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not
need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
17.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any
such meeting.
17.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either
in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.
17.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other
means of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis
and allowing an effective participation in the meeting. Participation in a meeting by these means is equivalent to partici-
pation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.
17.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or
represented at a meeting of the board of managers.
17.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,
if any, shall not have a casting vote.
17.7 The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in
writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be
the date of the last signature.
17.8 The majority of the meetings of the board of managers shall be held in the Grand Duchy of Luxembourg at the
registered office of the Company or at such other place in Luxembourg as may be specified in the convening notice of
such meeting.
Art. 18. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
18.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by
the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. Copies or excerpts of such minutes,
which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if any, or by any two (2)
managers.
18.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.
Art. 19. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances by (i) the
sole signature of any manager, or (ii) by the joint signatures or the sole signature of any person(s) to whom such signatory
power may have been delegated by the board of managers within the limits of such delegation.
E. Audit and supervision
Art. 20. Auditor(s).
20.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company
shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.
20.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting
of shareholders.
20.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
20.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d’entreprises agréé
(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies register and the
accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.
20.5 An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its
approval.
F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends
Art. 21. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end
on the thirty-first of December of the same year.
Art. 22. Annual accounts and allocation of profits.
22.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of
the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.
22.2 Of the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve. This
allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten per
cent (10%) of the share capital of the Company.
183768
L
U X E M B O U R G
22.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the
contributing shareholder agrees to such allocation.
22.4 In case of a share capital reduction, the Company’s legal reserve may be reduced in proportion so that it does
not exceed ten per cent (10%) of the share capital.
22.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the
remainder of the Company’s profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.
22.6 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company,
split as follows:
i. Tranche 10 Shares entitle their holders, pro rata, to the payment of a dividend representing zero point zero five per
cent (0.05%) per year of the nominal value of the Tranche 10 Shares issued by the Company;
ii. Tranche 9 Shares entitle their holders, pro rata, to the payment of a dividend representing zero point ten per cent
(0.10%) per year of the nominal value of the Tranche 9 Shares issued by the Company;
iii. Tranche 8 Shares entitle their holders, pro rata, to the payment of a dividend representing zero point fifteen per
cent (0.15%) per year of the nominal value of the Tranche 8 Shares issued by the Company;
iv. Tranche 7 Shares entitle their holders, pro rata, to the payment of a dividend zero point twenty per cent (0.20%)
per year of the nominal value of the Tranche 7 Shares issued by the Company;
v. Tranche 6 Shares entitle their holders, pro rata, to the payment of a dividend representing zero point twenty-five
per cent (0.25%) per year of the nominal value of the Tranche 6 Shares issued by the Company;
vi. Tranche 5 Shares entitle their holders, pro rata, to the payment of a dividend representing zero point thirty per
cent (0.30%) per year of the nominal value of the Tranche 5 Shares issued by the Company;
vii. Tranche 4 Shares entitle their holders, pro rata, to the payment of a dividend representing zero point thirty-five
per cent (0.35%) per year of the nominal value of the Tranche 4 Shares issued by the Company;
viii. Tranche 3 Shares entitle their holders, pro rata, to the payment of a dividend representing zero point forty per
cent (0.40%) per year of the nominal value of the Tranche 3 Shares issued by the Company;
ix. Tranche 2 Shares entitle their holders, pro rata, to the payment of a dividend representing zero point forty-five per
cent (0.45%) per year of the nominal value of the Tranche 2 Shares issued by the Company;
x. Tranche 1 Shares entitle their holders, pro rata, to the payment of a dividend representing zero point fifty per cent
(0.50%) per year of the nominal value of the Class 1 Shares issued by the Company;
each as long as they are in existence, and
the remainder shall be distributed to the Relevant Shares.
Art. 23. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
23.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared
by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may
not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable
reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles
of association do not allow to be distributed.
23.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the share-
holders subject to the provisions of the Law and these articles of association.
G. Liquidation
Art. 24. Liquidation.
24.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the
liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders
deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided,
the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the
Company.
24.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among
the shareholders in proportion to the number of shares of the Company held by them.
H. Final clause - Governing law
Art. 25. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance
with the Law.
<i>Transitional provisionsi>
1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 31 December
2015.
2. Interim dividends may be distributed during the Company’s first financial year.
183769
L
U X E M B O U R G
<i>Subscription and paymenti>
The 12,500 shares issued have been subscribed as follows:
(a) one thousand two hundred fifty (1,250) series 1 redeemable shares having a par value of one euro (EUR 1.-) each
(the “Tranche 1 Shares”);
(b) one thousand two hundred fifty (1,250) series 2 redeemable shares having a par value of one euro (EUR 1.-) each
(the “Tranche 2 Shares”);
(c) one thousand two hundred fifty (1,250) series 3 redeemable shares having a par value of one euro (EUR 1.-) each
(the “Tranche 3 Shares”);
(d) one thousand two hundred fifty (1,250) series 4 redeemable shares having a par value of one euro (EUR 1.-) each
(the “Tranche 4 Shares”);
(e) one thousand two hundred fifty (1,250) series 5 redeemable shares having a par value of one euro (EUR 1.-) each
(the “Tranche 5 Shares”);
(f) one thousand two hundred fifty (1,250) series 6 redeemable shares having a par value of one euro (EUR 1.-) each
(the “Tranche 6 Shares”);
(g) one thousand two hundred fifty (1,250) series 7 redeemable shares having a par value of one euro (EUR 1.-) each
(the “Tranche 7 Shares”);
(h) one thousand two hundred fifty (1,250) series 8 redeemable shares having a par value of one euro (EUR 1.-) each
(the “Tranche 8 Shares”);
(i) one thousand two hundred fifty (1,250) series 9 redeemable shares having a par value of one euro (EUR 1.-) each
(the “Tranche 9 Shares”); and
(j) one thousand two hundred fifty (1,250) series 10 redeemable shares having a par value of one euro (EUR 1.-) each
(the “Tranche 10 Shares” and together with Tranche 1 Shares, Tranche 2 Shares, Tranche 3 Shares, Tranche 4 Shares,
Tranche 5 Shares, Tranche 6 Shares, Tranche 7 Shares, Tranche 8 Shares and Tranche 9 Shares, the “Tranches” and
individually the “Tranche”)
The shares so subscribed have been fully paid up by a contribution in cash so that the amount of twelve thousand five
hundred euro (EUR 12,500) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
The total contribution in the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) is entirely allocated to the
share capital.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be
borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately one thousand one hundred
euro (EUR 1,100,-).
<i>Resolutions of the shareholdersi>
The incorporating shareholders, representing the entire share capital of the Company and having waived any convening
requirements, have passed the following resolutions:
1. The address of the registered office of the Company is set at 1, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
2. The following persons are appointed by EPIC I GP, S.à r.l. as proxy of the incorporating shareholders as managers
of the Company for an unlimited term:
(i) Mr Michael Phillips, born in St. Louis, USA on 1 February 1962, professionally residing at Possart Strasse 13, 81679
Munich, Germany;
(ii) Mr Geoffrey Henry, born on 5 May 1972, in Chênée, Belgium, professionally residing at Boulevard de la Foire 1,
L-1528 Luxembourg;
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-
ment.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,
this deed is worded in English followed by a German translation; at the request of the same appearing parties and in case
of divergence between the English and the German text, the English version shall prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name
and residence, the said proxyholder of the appearing parties signed together with the notary the present deed.
Follows the german version
Im Jahr eintausend vierzehn, am achtzehnten Tag des Monats November.
Vor uns, Edouard DELOSCH, Notar mit Amtssitz in Diekirch, Großherzogtum Luxemburg,
IST ERSCHIENEN:
183770
L
U X E M B O U R G
Firewall Hydrus TopCo, S.A., eine Aktiengesellschaft (société anonyme) errichtet mit Sitz in Boulevard de la Foire 1,
L-1528 Luxemburg, im Großherzogtum Luxembourg, mit einem Grundkapital von einundreißigtausend Euro (EUR 31
000) eingetragen im Handelsregister des Großherzogtums Luxembourgs mit der Nummer: B 191623 und
hier vertreten durch Julia Szafranska, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 17 November 2014,
ausgestellt in Luxembourg.
Besagte Vollmacht, welche von der erschienenen Partei und dem unterzeichnenden Notar ne varietur paraphiert
wurden, wird der vorliegenden Urkunde beigefügt um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.
Die erschienene Partei hat den amtierenden Notar ersucht, die Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung
(société à responsabilité limitée) zu beurkunden, welche sie mit der folgenden Satzung gründen will:
A. Name - Zweck - Dauer - Sitz
Art. 1. Name - Rechtsform. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée)
mit dem Namen Hydrus Luxco 2 S.à r.l. (die “Gesellschaft”), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August
1915 über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Ge-
sellschaften, sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung
oder auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung,
Kontrolle und Entwicklung ihrer Beteiligungen.
2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder
Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören, Garantien geben,
Sicherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.
2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere
durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren oder
Schuldtiteln, Schuldverschreibungen und Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheinen bzw. Wertpapie-
ren.
2.4 Die Gesellschaft kann auch als Gesellschafter/Aktionär für die Schulden und Verpflichtungen jeglicher luxembur-
gischen und ausländischen Gesellschaft mit unbeschränkter oder beschränkter Haftung handeln.
2.5 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur, sowie
solche, welche geistiges Eigentum oder Grundeigentum betreffen vornehmen, die ihr zur Erreichung dieser Zwecke
förderlich erscheinen.
Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden
welcher in und mit der für eine Satzungsänderung erforderlichen Form und Mehrheit gefasst wird.
Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in der Stadt Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Geschäftsführungsrates verlegt
werden. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in und mit der für eine Satzungsänderung erforderli-
chen Form und Mehrheit gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.
4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Geschäftsführungsrates im Groß-
herzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.
4.4 Sollte der Geschäftsführungsrat entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Ent-
wicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem
Gesellschaftssitz beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz bis zur endgültigen Beendigung dieser außerge-
wöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben keine
Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes eine
luxemburgische Gesellschaft bleibt.
B. Gesellschaftskapital - Anteile
Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500), bestehend aus
zwölftausendfünfhundert (12 500) Anteilen mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Anteil unterteilt wie
folgt:
(a) eintausendzweihundertfünfzig (1 250) rücknehmbaren Anteilen mit einem Nennwert von jeweils einem Euro (EUR
1,-) (die „Tranche 1 Anteile“);
183771
L
U X E M B O U R G
(b) eintausendzweihundertfünfzig (1 250) rücknehmbaren Anteilen mit einem Nennwert von jeweils einem Euro (EUR
1,-) (die „Tranche 2 Anteile“);
(c) eintausendzweihundertfünfzig (1 250) rücknehmbaren Anteilen mit einem Nennwert von jeweils einem Euro (EUR
1,-) (die „Tranche 3 Anteile“);
(d) eintausendzweihundertfünfzig (1 250) rücknehmbaren Anteilen mit einem Nennwert von jeweils einem Euro (EUR
1,-) (die „Tranche 4 Anteile“);
(e) eintausendzweihundertfünfzig (1 250) rücknehmbaren Anteilen mit einem Nennwert von jeweils einem Euro (EUR
1,-) (die „Tranche 5 Anteile“);
(f) eintausendzweihundertfünfzig (1 250) rücknehmbaren Anteilen mit einem Nennwert von jeweils einem Euro (EUR
1,-) (die „Tranche 6 Anteile“);
(g) eintausendzweihundertfünfzig (1 250) rücknehmbaren Anteilen mit einem Nennwert von jeweils einem Euro (EUR
1,-) (die „Tranche 7 Anteile“);
(h) eintausendzweihundertfünfzig (1 250) rücknehmbaren Anteilen mit einem Nennwert von jeweils einem Euro (EUR
1,-) (die „Tranche 8 Anteile“);
(i) eintausendzweihundertfünfzig (1 250) rücknehmbaren Anteilen mit einem Nennwert von jeweils einem Euro (EUR
1,-) (die „Tranche 9 Anteile“) und
(j) eintausendzweihundertfünfzig (1 250) rücknehmbaren Anteilen mit einem Nennwert von jeweils einem Euro (EUR
1,-) (die „Tranche 10 Anteile“ und zusammen mit den Tranche 1 Anteilen, Tranche 2 Anteilen, Tranche 3 Anteilen,
Tranche 4 Anteilen, Tranche 5 Anteilen, Tranche Anteilen 6 Anteilen, Tranche 7 Anteilen, Tranche 8 Anteilen und Tranche
9 Anteilen genannt „die Tranchen und in der Einzahl „die Tranche“).
5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in und mit der für
eine Satzungsänderung erforderlichen Form und Mehrheit gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.
5.3 Alle neuen Aktien, die durch Bareinlagen einzuzahlen sind, werden bevorzugt den bestehenden Gesellschaftern
innerhalb der jeweiligen Tranche angeboten. Im Falle einer Mehrheit von Gesellschaftern werden diese Aktien den Ge-
sellschaftern im Verhältnis zur Anzahl der von ihnen in der jeweiligen Tranche gehaltenen Anteile vom Gesellschaftskapital
angeboten. Die Geschäftsführung bestimmt den Zeitraum in dem dieses Vorzugsrecht ausgeübt werden kann und welcher
nicht weniger als dreißig (30) Tage vom Datum der Absendung eines an die Gesellschafter gesendeten Einschreibens,
welches die Eröffnung der Zeichnungsfrist ankündigt, beträgt. Die Gesellschafterversammlung kann das Vorzugsrecht der
bestehenden Gesellschafter durch einen Beschluss, welcher in und mit der für eine Satzungsänderung erforderlichen Form
und Mehrheit gefasst wird, begrenzen oder aufheben.
Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht über-
schreiten darf.
6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs, die Insolvenz
oder ein vergleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.
6.5 Kein Anteil einer bestimmten Tranche kann ich einen Anteil in einer anderen Tranche umgewandelt werden.
6.6 Die Anteile sind rückerwerbare Anteile im Sinne des Artikel 49-8 Gesetzes. Jede Rücknahme unterliegt den fol-
genden Bedingungen:
- nur vollständig bezahlte Anteile sollen zurückgenommen werden;
- die Bedingungen in Artikel 6.7 bis 6.15 dieser Satzung sind zu beachten;
- die Rücknahme kann nur durch Ausschüttungen getätigt werden, welche im Einklang mit Art. 72-1 des Gesetzes von
1915 ausgeschüttet worden sind oder durch Kapital, welches genau für diesen Zweck zur Verfügung gestellt worden ist;
- es soll ein Betrag entsprechend dem Nominalwert oder im Falle eines Fehlens dem Nennwert aller zurückgenommen
Anteile in eine Reserve eingestellt werden, welche nicht an die Anteilseigner ausgeschüttet werden kann, außer im Falle
einer Kapitalherabsetzung des Gesellschaftsvermögens. Diese Reserve soll dazu verwendet werden das Gesellschafts-
vermögen durch Kapitalisierung der Reserven zu erhöhen (diese Reserve ist für den Fall einer Rücknahme nicht notwendig
sofern für die Rücknahme die Erträge aus einer neuen Angelegenheit stammen, welche zum Zwecke der Rücknahme
bereitgestellt worden sind);
- die Rücknahme wird im Einklang mit dem Gesetz von 1915 veröffentlicht.
6.7 Das Stammkapital der Gesellschaft kann nur durch vollständige Löschung einer gesamten Tranche herabgesetzt
werden, was durch Rückkauf und Löschung aller Anteile dieser Tranche geschieht. Darüber beschließt von Zeit zu Zeit
die Geschäftsführung.
6.8 Die betreffende Tranche soll zurückerworben und gelöscht werden durch einen angemessenen Preis, welcher dem
Wert einer solchen Tranche auf dem freien Markt entspricht, wie untenstehend in Ziffer 6.9 definiert („Totaler Lösch-
ungsbetrag“).
183772
L
U X E M B O U R G
6.9 Im Falle einer Kapitalherabsetzung durch den Rückkauf und Löschung einer Tranche, gibt diese Tranche den In-
habern dieser Tranche das Recht pro rata am Verfügbaren Betrag (wie weiter unten definiert) dieser Tranche. Die Inhaber
von Anteilen der rückerworbenen und gelöschten Tranche erhalten von der Gesellschaft für jeden Anteil einen Betrag
entsprechend dem Löschungsbetrag pro Anteil (wie weiter unten definiert), welche von ihnen gehalten und gelöscht
worden sind.
6.10 Der Löschungsbetrag pro Anteil wird durch Teilung des Totalen Löschungsbetrages durch die Anzahl der in Rede
stehenden Anteile der rückgekauften und gelöschten Tranche von Anteilen ermittelt.
6.11 Der Totale Löschungsbetrag wird von der Geschäftsführung beschlossen und wird anhand des Kontostands des
jeweiligen Zwischenkontos ermittelt, welches nicht älter als acht (8) Tage vor dem Tag des Rückkaufs und der Löschung
der jeweiligen Tranche sein darf. Der Totale Löschungsbetrag für jede Tranche ist der Verfügbare Betrag erhöht durch
den Nominalwert der gelöschten Anteile) der jeweiligen Tranche im Zeitpunkt der Löschung der jeweiligen Tranche,
sofern nicht durch den Geschäftsführung anders gelöst. In jedem Falle darf der Totale Löschungsbetrag niemals höher als
der Verfügbare Betrag (erhöht durch den Nominalwert der gelöschten Anteilen) sein. Der Verwaltungsrat kann wählen,
ob er in seinem Beschluss über den Totalen Löschungsbetrag, die frei Verfügbaren Anteile oder Ausgleichbeträge he-
rausnimmt oder einfügt.
6.12 Der Verfügbare Betrag entspricht (i) dem gesamten Betrag des Nettogewinns der Gesellschaft (den Gewinnvor-
trag umfassend) erhöht durch (i) jede frei auszuschüttende Reserve und (ii) falls dies der Fall ist dem Wert des Agio oder
des Agio vergleichbaren Betrages und der Ermäßigung der gesetzlichen Rücklage in Bezug auf die jeweils zu löschende
Tranche, aber um den Betrag gekürzt durch (ii) den Verlust (den Verlustvortrag umfassend), (iii) jeden einzusetzenden
Betrag für die nicht ausschüttbaren Reserven im Sinne des Gesetzes von 1915 oder dieser Satzung, welcher in dem
relevanten Zwischenkonto enthalten ist und (iii) jede angefallene und unbezahlte Dividende bis zum Betrag welcher noch
nicht den NP reduziert hat (um Zweifel zu umgehend ohne doppelte Buchung) (ii) bis zu dem Punkt, dass die Aktionäre
der jeweiligen Tranche anspruchsberechtigt auf Ausschüttung der Dividende nach Artikel 28 dieser Satzung sind. Daraus
ergibt sich: AA= (NP + P + CR) - (L + LR + LD). Dabei gilt: AA=Verfügbarer Betrag; NP= Nettogewinn (den Gewinnvortrag
umfassend); P= jede frei auszuschüttende Reserve; CR= der Betrag des Agiorückgangs und des gesetzlichen Rücklagen-
rückgangs bezogen auf die zu löschende Tranche; L= Verluste (den Verlustvortrag umfassend); LR= jeder einzusetzende
Betrag für die nicht ausschüttbaren Reserven entsprechend dem Gesetz von 1915 oder dieser Satzung; LD= jede ange-
fallene und unbezahlte Dividende bis zum Betrag welcher noch nicht den NP reduziert hat.
6.13 Der Löschungsbetrag pro Anteil wird fällig und zahlbar für die Gesellschaft im Zeitpunkt des Rückkaufs und der
Löschung des Anteils der jeweiligen Tranche.
6.14 Die Anteile sollen in umgekehrter alphanumerischer Reihenfolge der Tranche beginnend bei Tranche 10 rücker-
worben werden.
6.15 Untergeordnete Anteile einer bestimmten Tranche sind nur dann dem Rückkauf zugänglich, wenn alle Anteile der
übergeordneten Tranche vollständig zurückgekauft worden sind. Jede nach diesem Artikel 6 rückkaufbarer Anteil trägt
die Bezeichnung „Relevante Anteile“.
Art. 7. Anteilsregister und Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden
kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.
7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten
wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft
ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.
7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.
7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern mit
einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden.
7.5 Jede Übertragung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten gemäß Artikel 1690 des Code Civil
wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung zugestimmt
hat.
7.6 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters an neue Gesellschafter nur mit Zustimmung der
überlebenden Gesellschaftern mit einer Mehrheit von drei Vierteln der von Ihnen gehaltenen Rechte übertragen werden.
Eine derartige Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn die Anteile Eltern, Nachkommen oder dem/der überlebenden
Ehepartner/in übertragen werden oder jedem anderen gesetzlichen Erben des verstorbenen Gesellschafters.
C. Entscheidungen der Gesellschafter
Art. 8. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
8.1 Die Gesellschafterversammlung der Gesellschafter ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch Gesetz und
diese Satzung übertragen wurden.
8.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Zahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.
183773
L
U X E M B O U R G
8.3 Falls und solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, dürfen gemeinsame Ent-
scheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung der Gesellschafter vorbehalten wären, schriftlich gefasst
werden. In diesem Fall erhält jeder Gesellschafter den Text der ausformulierten vorgeschlagenen Beschlüsse und übt sein
Stimmrecht schriftlich aus.
8.4 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschriften
von Abschnitt XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jeder Bezug auf die „Gesellschafter-
versammlung“ in der vorliegenden Satzung als Bezug auf den Alleingesellschafter, je nach Zusammenhang und soweit
anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingesellschafter ausgeübt.
Art. 9. Gesellschafterversammlung der Gesellschafter. Falls die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschaf-
ter hat, muss jährlich innerhalb von sechs (6) Monaten vor dem Ende des Geschäftsjahres mindestens eine Gesellschaf-
terversammlung der Gesellschafter in Luxemburg am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort abgehalten werden,
wie in der Einberufung zu dieser Versammlung genauer bestimmt. Andere] Gesellschafterversammlungen finden an dem
Ort und zu der Zeit statt, welcher in der entsprechenden Einberufung genauer bestimmt werden. Falls alle Gesellschafter
in einer Versammlung anwesend oder vertreten sind und auf sämtliche Einberufungsformalitäten verzichtet haben, kann
die Gesellschafterversammlung auch ohne vorherige Ankündigung oder Veröffentlichung abgehalten werden.
Art. 10. Quorum und Abstimmung.
10.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.
10.2 Vorbehaltlich anderer gesetzlicher Regelungen oder dieser Satzung, die ein höheres Mehrheitsverhältnis vorsehen,
bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte
des Gesellschaftskapitals innehaben. Falls diese Mehrheit in einer ersten Gesellschafterversammlung oder einer ersten
schriftlichen Konsultation der Gesellschafter nicht erreicht wird, können die Anteilseigner ein weiteres Mal mit derselben
Tagesordnung einberufen werden oder per Einschreiben dieselben schriftlichen Beschlussvorschläge erhalten und Ent-
scheidungen werden wirksam mit der Mehrheit der wirksam abgegebenen Stimmen gefasst, unabhängig vom Anteil des
durch sie vertretenen Gesellschaftskapitals.
Art. 11. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.
Art. 12. Änderung der Satzung. Eine Änderung der Satzung erfordert die Zustimmung (i) einer Mehrheit der Gesell-
schafter, die mindestens (ii) eine Mehrheit von drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertritt.
D. Geschäftsführung
Art. 13. Befugnisse des Einzelgeschäftsführers -Zusammensetzung und Befugnisse des Geschäftsführungsrates.
13.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Ge-
schäftsführer hat, bilden diese einen Geschäftsführungsrat.
13.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „Einzelgeschäfts-
führer“ nicht ausdrücklich verwendet wird ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Geschäftsführungsrat“ als Verweis
auf den Einzelgeschäftsführer auszulegen.
13.3 Der Geschäftsführungsrat verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, im Namen der Gesellschaft zu handeln
und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.
13.4 Die Gesellschaft bevollmächtigt die EPIC I GP S.à r.l., eine GmbH (société à responsabilité limitée) mit Sitz am
Boulevard de la Foire 1, L-1528 Großherzogtum Luxembourg eingetragen im Handelsregister unter der Nummer B186222
(die „Bevollmächtigte“) die Gesellschaft selbst, mit Untervertretungsvollmacht, in ihrem Namen bei jeder Aktionärs- oder
Interessenversammlung oder schriftlichen Beschlüssen von Unternehmen, Gesellschaften oder anderen juristischen Per-
sonen an denen die Gesellschaft Aktien, Anteile oder andere Interessen hält nur in Bezug auf (i) die Bestellung und
Abberufung von Verwaltungsratsmitgliedern, Geschäftsführern oder anderen Mitgliedern von führenden, beherrschenden
oder überwachenden Organen an deren Entscheidung die Gesellschaft mitzuwirken hat und (ii) Änderungen von diesen
Satzungen, von Gesellschaftsverträgen oder Geschäftsordnungen, welche die Bestellung oder Abberufung von Verwal-
tungsratsmitgliedern, Geschäftsführern oder anderen Mitgliedern von führenden, beherrschenden oder überwachenden
Organen betreffen und an deren Entscheidung die Gesellschaft mitzuwirken hat, zu vertreten.
Art. 14. Wahl, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
14.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung gewählt, welche ihre Bezüge und
Amtszeit festlegt und Artikel 13.4 entspricht.
14.2 Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund durch einen Beschluss von Gesellschaftern, die mehr als die
Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, gewählt oder abberufen werden.
Art. 15. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
15.1 Scheidet ein Geschäftsführer durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Konkurs, Rücktritt oder aus einem anderen Grund
aus seinem Amt, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen die ursprüng-
liche Amtszeit nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesellschafterversammlung ausgefüllt werden, welche
183774
L
U X E M B O U R G
im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften und Artikel 13.4 über die endgültige Neubesetzung entschei-
det.
15.2 Für den Fall, dass der Einzelgeschäftsführer aus seinem Amt ausscheidet, muss die frei gewordene Stelle unver-
züglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.
Art. 16. Einladung zu Sitzungen des Geschäftsführungsrats.
16.1 Der Geschäftsführungsrat versammelt sich auf Einberufung [eines] Mitglieds. Die Geschäftsführungsratssitzungen
finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.
16.2 Die Geschäftsführer werden mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung anberaumten
Datum zu jeder Sitzung des Geschäftsführungsrats schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe der
Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, wenn alle Geschäftsführer
schriftlich, per Fax, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abgegeben haben,
wobei eine Kopie einer solchen unterzeichneten Zustimmung ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung zu Sitzungen
des Geschäftsführungsrats ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss des Geschäfts-
führungsrats bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.
16.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle
Einladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Ge-
schäftsführungsrats diesen zugestimmt und diese unterzeichnet haben.
Art. 17. Durchführung von Geschäftsführungsratssitzungen.
17.1 Der Geschäftsführungsrat kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Geschäftsführungsrat
kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise Mitglied des Geschäftsführungsrats sein muss und
der für die Protokollführung der Sitzungen des Geschäftsführungsrats verantwortlich ist.
17.2 Sitzungen des Geschäftsführungsrats werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Geschäftsführungsrats
geleitet. In dessen Abwesenheit kann der Geschäftsführungsrat ein anderes Mitglied des Geschäftsführungsrats durch
einen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Mitglieder als Vorsitzenden pro tempore ernennen.
17.3 Jedes Mitglied des Geschäftsführungsrats kann an einer Sitzung des Geschäftsführungsrats teilnehmen, indem es
ein anderes Mitglied des Geschäftsführungsrats schriftlich, oder durch Fax, per E-Mail oder ein anderes vergleichbares
Kommunikationsmittel bevollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein
Mitglied des Geschäftsführungsrats kann einen oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.
17.4 Eine Sitzung des Geschäftsführungsrats kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein an-
deres Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu
hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel
ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung wird als am Sitz der
Gesellschaft abgehalten erachtet.
17.5 Der Geschäftsführungsrat kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest die Mehrheit seiner
Mitglieder in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.
17.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Geschäftsführungsrats
teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Geschäftsführungsrats, falls vorhanden,
hat im Falle von Stimmgleichheit die entscheidende Stimme.
17.7 Der Geschäftsführungsrat kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung, per
Fax, E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Die Geschäftsführer können ihre Zustimmung
getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreffenden Beschlusses
nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.
17.8 Der Großteil aller Geschäftsführerratsversammlungen werden am eingetragenen Sitz der Gesellschaft im Groß-
herzogtum Luxembourg abgehalten oder aber an jedem anderen Ort in Luxembourg, wie in der Ladung zur Versammlung
angegeben.
Art. 18. Protokoll von Sitzungen des Geschäftsführungsrats - Protokoll der Entscheidungen des Einzelgeschäftsführers.
18.1 Das Protokoll einer Sitzung des Geschäftsführungsrats wird vom Vorsitzenden des Geschäftsführungsrates (falls
vorhanden) oder, im Falle seiner Abwesenheit, falls vorhanden, von dem Vorsitzenden pro tempore und dem Protokoll-
führer oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in
einem Gerichtsverfahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Geschäfts-
führungsrates (falls vorhanden), oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet.
18.2 Die Entscheidungen des Einzelgeschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom Einzelge-
schäftsführer unterzeichnet wird. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Einzelgeschäftsführer unterzeichnet.
Art. 19. Geschäfte mit Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Umständen durch (i) die alleinige
Unterschrift eines jeden Mitglieds des Geschäftsführungsrats oder (ii) durch die gemeinsame oder die alleinige Unterschrift
183775
L
U X E M B O U R G
jedweder Person(en) der/denen eine Unterschriftsbefugnis durch den Geschäftsführungsrat übertragen worden ist, im
Rahmen dieser Befugnis wirksam verpflichtet.
E. Aufsicht und Prüfung der Gesellschaft
Art. 20. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
20.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der
Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)). Die Gesellschafterversammlung
ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.
20.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
20.3 Der Rechnungsprüfer hat ein unbeschränktes Recht der permanenten Überprüfung und Kontrolle aller Geschäfte
der Gesellschaft.
20.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes vom 19. Dezember 2002 betreffend
das Handels- und Gesellschaftsregister sowie zur Buchhaltung und zum Jahresabschluss von Unternehmen in seiner ge-
änderten Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d’entreprise agréé(s)) ernennt, entfällt
die Funktion des Rechnungsprüfers.
20.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die
Gesellschafterversammlung abberufen werden.
F. Geschäftsjahr - Jahresabschlussgewinne - Abschlagsdividenden
Art. 21. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am
einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.
Art. 22. Jahresabschluss und Gewinn.
22.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Geschäftsführungsrat erstellt im Einklang
mit den gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrech-
nung.
22.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage
der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.
22.3 Durch einen Gesellschafter erbrachte Einlagen in Rücklagen können mit Zustimmung dieses Gesellschafters
ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.
22.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage entsprechend herabgesetzt
werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.
22.5 Auf Vorschlag des Geschäftsführungsrates bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit dem Gesetz
von 1915 und den Bestimmungen dieser Satzung, wie der verbleibende Bilanzgewinn der Gesellschaft verwendet werden
soll.
22.6 Ausschüttungen an die Gesellschafter erfolgen proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehalt-
enen Anteile und unterteilt sich wie folgt:
i. Tranche 10 Anteile berechtigen den Inhaber zum Einzug einer Dividende, pro rate, von Null Komma Null Fünf Prozent
(0,05%) pro Jahr vom Nominalwert der in Tranche 10 ausgegeben Anteile;
ii. Tranche 9 Anteile berechtigen den Inhaber zum Einzug einer Dividende, pro rate, von Null Komma zehn Prozent
(0,10%) pro Jahr vom Nominalwert der in Tranche 9 ausgegeben Anteile;
iii. Tranche 8 Anteile berechtigen den Inhaber zum Einzug einer Dividende, pro rate, von Null Komma Fünfzehn Prozent
(0,15%) pro Jahr vom Nominalwert der in Tranche 8 ausgegeben Anteile;
iv. Tranche 7 Anteile berechtigen den Inhaber zum Einzug einer Dividende, pro rate, von Null Komma Zwanzig Prozent
(0,20%) pro Jahr vom Nominalwert der in Tranche 7 ausgegeben Anteile;
v. Tranche 6 Anteile berechtigen den Inhaber zum Einzug einer Dividende, pro rate, von Null Komma Fünfundzwanzig
Prozent (0,25%) pro Jahr vom Nominalwert der in Tranche 6 ausgegeben Anteile;
vi. Tranche 5 Anteile berechtigen den Inhaber zum Einzug einer Dividende, pro rate, von Null Komma Dreisig Prozent
(030%) pro Jahr vom Nominalwert der in Tranche50 ausgegeben Anteile;
vii. Tranche 4 Anteile berechtigen den Inhaber zum Einzug einer Dividende, pro rate, von Null Komma Fünfunddreisig
Prozent (0,35%) pro Jahr vom Nominalwert der in Tranche 4 ausgegeben Anteile;
viii. Tranche 3 Anteile berechtigen den Inhaber zum Einzug einer Dividende, pro rate, von Null Komma Vierzig Prozent
(0,40%) pro Jahr vom Nominalwert der in Tranche 3 ausgegeben Anteile;
ix. Tranche 2 Anteile berechtigen den Inhaber zum Einzug einer Dividende, pro rate, von Null Komma Fünfundvierzig
Prozent (0,45%) pro Jahr vom Nominalwert der in Tranche 2 ausgegeben Anteile;
x. Tranche 1 Anteile berechtigen den Inhaber zum Einzug einer Dividende, pro rate, von Null Komma Fünfzig Prozent
(0,50%) pro Jahr vom Nominalwert der in Tranche 1 ausgegeben Anteile;
solange diese noch bestehen und
183776
L
U X E M B O U R G
der Rest wird auf die Relevanten Anteile verteilt.
Art. 23. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
23.1 Der Geschäftsführungsrat kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche vom
Geschäftsführungsrat vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur Verfü-
gung stehen. Der ausschüttbare Betrag darf nicht die Summe der seit dem Ende des vergangenen Geschäftsjahres
angefallenen Gewinne, gegebenenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne und ausschüttbare Rücklagen, beziehungs-
weise vermindert durch vorgetragene Verluste oder Summen, die nach dieser Satzung oder dem Gesetz von 1915 einer
Rücklage zugeführt werden müssen, übersteigen.
23.2 Das Agio, andere Kapitalreserven und andere ausschüttbare Rücklagen können, im Einklang mit den Bestimmungen
des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung, frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.
G. Liquidation
Art. 24. Liquidation.
24.1 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Abwicklung durch
einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, die über die
Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit nichts anderes
bestimmt wird haben die Liquidatoren die weitestgehenden Rechte für die Verwertung der Vermögenswerte und die
Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
24.2 Der sich nach Verwertung der Vermögenswerte und Tilgung der Verbindlichkeiten ergebende Überschuss wird
an die Gesellschafter proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehaltenen Anteile verteilt.
H. Schlussbestimmungen - Anwendbares recht
Art. 25. Anwendbares Recht. Für alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten gelten die Regelungen des
Gesetzes von 1915.
<i>Übergangsbestimmungeni>
1. Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 2015.
2. Abschlagsdividenden können auch während des ersten Geschäftsjahres der Gesellschaft ausgeschüttet werden.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Die zwölftausendfünfhundert ausgegebenen Anteile wurden wie folgt gezeichnet:
(a) eintausendzweihundertfünfzig (1 250) rücknehmbare Anteile mit einem Nennwert von jeweils einem Euro (EUR
1,-) (die „Tranche 1 Anteile“);
eintausendzweihundertfünfzig (1 250) rücknehmbare Anteile mit einem Nennwert von jeweils einem Euro (EUR 1,-)
(die „Tranche 2 Anteile“);
eintausendzweihundertfünfzig (1 250) rücknehmbare Anteile mit einem Nennwert von jeweils einem Euro (EUR 1,-)
(die „Tranche 3 Anteile“);
eintausendzweihundertfünfzig (1 250) rücknehmbare Anteile mit einem Nennwert von jeweils einem Euro (EUR 1,-)
(die „Tranche 4 Anteile“);
eintausendzweihundertfünfzig (1 250) rücknehmbare Anteile mit einem Nennwert von jeweils einem Euro (EUR 1,-)
(die „Tranche 5 Anteile“);
eintausendzweihundertfünfzig (1 250) rücknehmbare Anteile mit einem Nennwert von jeweils einem Euro (EUR 1,-)
(die „Tranche 6 Anteile“);
eintausendzweihundertfünfzig (1 250) rücknehmbare Anteile mit einem Nennwert von jeweils einem Euro (EUR 1,-)
(die „Tranche 7 Anteile“);
eintausendzweihundertfünfzig (1 250) rücknehmbare Anteile mit einem Nennwert von jeweils einem Euro (EUR 1,-)
(die „Tranche 8 Anteile“);
eintausendzweihundertfünfzig (1 250) rücknehmbare Anteile mit einem Nennwert von jeweils einem Euro (EUR 1,-)
(die „Tranche 9 Anteile“) und
eintausendzweihundertfünfzig (1 250) rücknehmbare Anteile mit einem Nennwert von jeweils einem Euro (EUR 1,-)
(die „Tranche 10 Anteile“ und zusammen mit den Tranche 1 Anteilen, Tranche 2 Anteilen, Tranche 3 Anteilen, Tranche
4 Anteilen, Tranche 5 Anteilen, Tranche Anteilen 6 Anteilen, Tranche 7 Anteilen, Tranche 8 Anteilen und Tranche 9
Anteilen genannt „die Tranchen und in der Einzahl „die Tranche“).
Die Einlage für so gezeichnete Anteile wurde vollständig in bar erbracht, so dass der Gesellschaft ein Betrag in Höhe
von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) zur Verfügung steht, was dem unterzeichnenden Notar nachgewiesen
wurde.
Nachweis für die Existenz und den Wert der oben bezeichneten Einlagen wurde dem unterzeichnenden Notar er-
bracht.
183777
L
U X E M B O U R G
<i>Auslageni>
Die der Gesellschaft aufgrund oder im Zusammenhang mit der Gründung entstandenen Kosten, Gebühren, Honorare
und Auslagen werden auf eintausend einhundert Euro (EUR 1.100,-) geschätzt.
<i>Beschlüsse der Gesellschafteri>
Die Gründer, welche das gesamte Gesellschaftskapital repräsentieren und welche auf eine formelle Einberufungsbe-
kanntmachung verzichten, haben folgende Beschlüsse gefasst:
1. Der Sitz der Gesellschaft ist in at Boulevard de la Foire, 1, L-1528 Luxembourg.
2. Die folgenden Personen werden durch EPIC I GP, S.à r.l. in Vertretung für die Gründer, für unbegrenzte Zeit als
Geschäftsführer der Gesellschaft ernannt:
(i) Herr Michael Phillips, geboren in St. Louis, USA, am 1. Februar 1962,wohnhaft in Possard Strasse 13, 81679 München,
Deutschland;
(ii) Herr Geoffrey Henry, geboren in Chênée, Belgien, am 5. Mai 1972, wohnhaft in Boulevard de la Foire 1, L-1528
Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg;
Worüber diese notarielle Urkunde, in Luxemburg zum eingangs erwähnten, Datum aufgenommen wurde.
Der beurkundende Notar, welcher die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit auf Ersuchen der erschienenen
Parteien, dass die Urkunde auf Anfrage der erschienenen Parteien auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen
Übersetzung. Auf Ersuchen derselben erschienenen Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen
und dem deutschen Text, soll die englische Fassung vorrangig sein.
Nachdem das Dokument der Bevollmächtigten der erschienenen Parteien vorgelesen wurde, welche dem Notar mit
Namen, Vornamen und Wohnsitz bekannt ist, hat die Bevollmächtigte die Urkunde zusammen mit dem Notar unter-
zeichnet.
Signé: J. SZAFRANSKA, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 19 novembre 2014. Relation: DIE/2014/14706. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.
<i>Le Receveuri> (signé) pd: RECKEN.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Diekirch, le 21 novembre 2014.
Référence de publication: 2014185596/820.
(140207814) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2014.
Greganna Luxembourg, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 192.120.
STATUTES
In the year two thousand and fourteen, on the thirteenth day of the month of November;
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned,
APPEARED:
The private unlimited company incorporated under laws of the Isle of Man “Creganna Medical Technology Unlimited”,
having its registered office in IM1 1JA Douglas, 18 Athol Street (Isle of Man), registered in Isle of Man Companies Registry
under number 122255C,
here represented by Mr. Christian DOSTERT, notary clerk, residing professionally in L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean
Engling, (the “Proxy-holder”), by virtue of a proxy given under private seal; such proxy, after having been signed “ne
varietur” by the Proxy-holder and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded
with it.
Such appearing party, represented as said before, has required the officiating notary to enact the deed of association
of a private limited liability company (“société à responsabilité limitée”) to establish as follows:
Art. 1. There is formed by the present appearing party mentioned above and all persons and entities who may become
shareholders in the future, a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed by
the laws pertaining to such an entity, and in particular the Law dated 10
th
August, 1915 on commercial companies, as
well as by the present articles (hereafter the “Company”).
Art. 2. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of
participations in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control and development
of those participations.
183778
L
U X E M B O U R G
In particular, the Company may use its funds to establish, manage, develop and dispose of a portfolio of securities and
patents of whatever origin, to participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by way
of investment, subscription, underwriting or option, securities and patents, to realize them by way of sale, transfer,
exchange or otherwise, to develop such securities and patents, to grant to companies in which the Company has a
participation, any assistance, loans, advances and guarantees.
The Company may engage in any transactions involving immovable and movable property. The Company may acquire,
transfer and manage any real estate of whatever kind in whatever country or location. The Company may further engage
and execute any operations which pertain directly or indirectly to the management and the ownership of real estate. The
Company may also carry out a licensing activity or trademark as well as a financing activity to its subsidiaries.
The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue by way of private placement only,
notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities.
The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsi-
diaries or companies in which it has a direct or indirect interest, even not substantial, or any company being a direct or
indirect shareholder of the Company or any affiliated company belonging to the same group as the Company (hereafter
referred as the “Connected Companies”). It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to
secure its obligations or the obligations of its Connected Companies. The Company may further pledge, transfer, en-
cumber or otherwise create security over some or all of its assets.
The Company may carry out any industrial or commercial activity which directly or indirectly favours the realisation
of its object.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will have the name of “Creganna Luxembourg”.
Art. 5. The registered office is established in the municipality of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
The Registered Office may be transferred to any other place within the same municipality in the Grand Duchy of
Luxembourg by decision of the Board of Managers or by a resolution of an extraordinary general meeting of its share-
holders.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. The Company's capital is set at sixteen thousand eight hundred seventy-five United States Dollars (USD
16,875.-), represented by sixteen thousand eight hundred seventy-five (16,875) shares with a par value of one United
States Dollar (USD 1.-) each.
Any amendment of any stipulations of the present article 6 shall be carried out by a resolution of the shareholders,
adopted at an extraordinary general meeting of the shareholders having obtained a unanimous vote of the shareholders.
Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the shareholders
meeting, in accordance with article 14 of these articles of association.
Art. 8. Each of the shares confers a voting right and each shareholder has voting rights commensurate to his share-
holding. Each share shall entitle its owner to equal rights to any distribution of dividends.
Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint
co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the
requirements of article 189 of the law of August 10
th
, 1915 on commercial companies.
Art. 11. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the
shareholders will not bring the Company to an end.
Art. 12. The Company is managed by a board of managers. The board of managers is composed by managers of category
A and category B (the “A Manager” and the “B Manager”). The managers need not to be shareholders. The managers are
appointed, revoked and replaced by the general shareholder meeting, by a decision adopted by shareholders owning more
than half of the share capital.
In dealing with third parties, the managers will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the terms of
this article 12 shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders
fall within the competence of the board of managers.
The board of managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to be present, his
place will be taken by election among managers present at the meeting.
The board of managers may elect a secretary among its members.
183779
L
U X E M B O U R G
The meetings of the board of managers are convened by the chairman, the secretary or by any two Managers. The
board of managers may validly debate without prior notice if all the managers are present or represented. A manager
may be represented by another member of the board of managers of the same category.
The board of managers can only validly debate and take decisions if at least half of the managers is present or repre-
sented with always at least one (1) A Manager and one (1) B Manager. Any decisions by the board of managers shall be
taken by unanimous vote of all managers present or represented.
One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of com-
munication initiated from Luxembourg enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate
with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a decision can be
documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members
having participated.
A written decision, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the
board of managers, which was duly convened and held.
Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content
signed by all the members of the board of managers.
The board of managers may subdelegate powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.
The board of managers will determinate the agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of the
period of representation and any other relevant conditions of said agency.
Towards third parties, the Company will be validly bound by the joint signature of one A Manager and one B Manager
or by signature of any special agent as decided by the board of managers, provided he/she acts within the limits of the
powers granted by the board of managers.
Art. 13. The managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to any commitment validly
made by them in the name of the Company.
Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number
of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions
are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority of the
shareholders owning at least three quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the law of August
10
th
1915, as amended.
Art. 15. The Company is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of share-
holders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not exceed
six (6) years.
Art. 16. The Company’s year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December.
Art. 17. Each year, with reference to December 31
st
, the Company’s accounts are established and the manager, or
in case of plurality of managers, the board of managers prepares an inventory including an indication of the value of the
company’s assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 18. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amor-
tisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share
capital.
The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their shareholding in the
Company.
Interim dividends may be paid in respect of the following conditions:
1. Only the board of managers is authorized to decide upon any such distribution;
2. Interim accounts shall be drawn up by the board of managers showing that the funds available for distribution are
sufficient;
3. The amount to be distributed may not exceed total profits made since the end of the last financial year for which
the annual accounts have been approved, plus any profits carried forward and sums drawn from reserves available for
this purpose, less losses carried forward and any sums to be placed to reserve pursuant to the requirements of the law
or of the articles;
Where the payments on account of interim dividends exceed the amount of the dividend subsequently decided upon
by the general meeting, they shall, to the extent of the overpayment, be deemed to have been paid on account of the
next dividend.
183780
L
U X E M B O U R G
Art. 19. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
Art. 20. Reference is made to the provisions of the law of 10
th
August, 1915, as amended, for all matters for which
no specific provision is made in these articles of association.
<i>Transitory provisionsi>
The first financial year shall begin today and it shall end on December 31
st
2014.
<i>Subscription and paymenti>
The Articles thus having been established, the sixteen thousand eight hundred seventy-five (16,875) shares have been
subscribed by the sole shareholder, the company “Creganna Medical Technology Unlimited”, pre-designated and repre-
sented as said before, and fully paid up by the aforesaid subscriber by payment in cash, so that the amount of sixteen
thousand eight hundred seventy-five United States Dollars (USD 16,875.-) is from this day on at the free disposal of the
Company, as it has been proved to the officiating notary by a bank certificate, who states it expressly.
<i>Declarationi>
The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 183
of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, and expressly states that they have been fulfilled.
<i>Resolutions taken by the sole shareholderi>
The aforementioned appearing party, representing the whole of the subscribed share capital, has adopted the following
resolutions as sole shareholder:
1) The number of managers is set at three (3). The sole shareholder appoints as managers of the Company for an
unlimited period of time:
<i>A Manager:i>
- Mr. Zubair JAVEED born on May 17
th
, 1972 in Stockport (United Kingdom), residing at 8 The Parklands, Clarinbridge,
County Galway (Ireland);
<i>B Managers:i>
- Mr. Quentin DE NEVE DE RODEN, born on May 27
th
, 1975 in Ixelles (Belgium), professionally residing at 5, rue
Guillaume Kroll L-1882 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg);
- Mrs. Ingrid MOINET, born on December 5
th
, 1975 in Bastogne (Belgium), professionally residing at 5, rue Guillaume
Kroll L-1882 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
According to article 12 of the Articles, the Company is validly bound by the joint signature of a category A manager
and a category B manager.
2) The following company is appointed as statutory auditor for the audit of the annual accounts as at December 31,
2014:
The public limited company “ERNST & YOUNG LUXEMBOURG”, having its registered office in L-5365 Munsbach, 7,
rue Gabriel Lippmann, registered with the Trade and Companies Registry of Luxembourg, section B, under number 88019.
3) The registered office is established in L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand Euros.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above
appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
party, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the Proxy-holder of the appearing party, acting as said before, known to the notary
by name, first name, civil status and residence, the said Proxy-holder has signed with Us, the notary, the present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille quatorze, le treizième jour du mois de novembre;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné;
A COMPARU:
183781
L
U X E M B O U R G
La private unlimited company constituée sous les lois de l’Ile de Man “Creganna Medical Technology Unlimited”, ayant
son siège social à IM1 1JA Douglas, 18 Athol Street (Ile de Man), inscrite au Isle of Man Companies Registry sous le
numéro 122255C,
ici représentée par Monsieur Christian DOSTERT, clerc de notaire, demeurant professionnellement à L-1466 Lu-
xembourg, 12, rue Jean Engling, (le “Mandataire”), en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée; laquelle
procuration, après avoir été signée “ne varietur” par le Mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte afin d'être enregistrée avec lui.
Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire d'arrêter les statuts
d'une société à responsabilité limitée à constituer comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes par le comparant et toutes les personnes qui pourraient devenir associés par
la suite, de la société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, et notamment celle du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (ci-après la “Société”).
Art. 2. La Société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à l’acquisition et la
prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le
contrôle et le développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un
portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.
La Société pourra s’engager dans toutes transactions concernant des biens immobiliers et mobiliers. La Société pourra
acquérir, transférer, louer et gérer tous biens immeubles de toutes sortes et situés dans tous pays. La Société pourra
également engager et exécuter toutes opérations appartenant directement ou indirectement à la gestion et à la propriété
de tels biens immobiliers. La Société pourra également exercer une activité de licence de marque de fabrique ainsi qu’une
activité de financement de ses filiales.
La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, par voie
d'émission privée uniquement, à l’émission d'obligations, billets à ordre et débentures, et ainsi que tout autre instrument
de dette et/ou titres de capital.
La Société peut fournir des financements y compris les bénéfices de tout emprunt et/ou émission de titres de dettes
à ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte, y compris non substantielle, ou
toute société étant un associé direct ou indirect de la Société ou toute société affiliée appartenant au même groupe que
la Société (ci-après dénommées les "Sociétés Liées"). La Société peut également consentir des garanties ou sûretés en
faveur de tierce parties en vue de l’exécution des obligations de ses Sociétés Liées. La Société peut nantir, céder, grever
ou autrement créer toute sûreté sur tout ou partie de ses biens.
La Société pourra finalement accomplir toutes opérations, activités commerciales ou industrielles, qui favoriseront
directement ou indirectement la réalisation de son objet.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société prend la dénomination de “Creganna Luxembourg”.
Art. 5. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre commune du Grand Duché de Luxembourg par simple décision du Conseil de
Gérance ou par décision des associés.
La Société peut ouvrir des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu'à l’étranger.
Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à la somme de seize mille huit cent soixante-quinze dollars américains
(16.875,- USD) représenté par seize mille huit cent soixante-quinze (16.875) parts sociales d'une valeur nominale d'un
dollar américain (1,- USD) chacune.
Tout amendement des stipulations du présent article 6 devra être décidé par une résolution des associés adoptée à
l’unanimité en assemblée générale extraordinaire des associés.
Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l’associé unique sinon de l’assemblée
des associés, conformément à l’article 14 des présents statuts.
Art. 8. Chaque Part sociale Rachetable confère un droit de vote identique et chaque associé dispose de droits de vote
proportionnels à sa participation dans le capital social. Les part sociales auront une valeur pari passu les unes avec les
autres et assureront à leur propriétaire des droits égaux de distribution de dividendes.
Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune
d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule
et même personne.
183782
L
U X E M B O U R G
Art. 10. Toutes cessions de parts sociales détenues par l’associé unique sont libres.
En cas de pluralité d'associés, les parts sociales peuvent être cédées, à condition d’observer les exigences de l’article
189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Art. 11. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé unique, sinon d’un des associés, ne mettent pas
fin à la Société.
Art. 12. La Société est gérée par un Conseil de Gérance. Le Conseil de Gérance est composé de gérants de catégorie
A et de catégorie B (le “Gérant” et le “Gérant B”).
Les gérants n’ont pas besoin d’être associés. Les gérants sont désignés, révoqués et remplacés par l’assemblée des
associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital social.
Vis-à-vis des tiers, les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances
et pour exécuter et approuver tous les actes et opérations en relation avec l’objet social et sous réserve du respect des
dispositions du présent article 12.
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale des associés
sont de la compétence du Conseil de Gérance.
Le Conseil de Gérance pourra élire un président parmi ses membres. Si le président est empêché, sa place sera
octroyée par élection parmi les gérants présents à la réunion.
Le Conseil de Gérance peut élire un secrétaire parmi ses membres.
Les réunions du Conseil de Gérance seront convoquées par le président, le secrétaire ou par deux gérants.
Le Conseil de Gérance pourra valablement délibérer sans convocation lorsque tous les gérants sont présents ou
représentés. Un gérant peut être représenté par un autre gérant du Conseil de Gérance de la même catégorie.
Le Conseil de Gérance ne pourra valablement délibérer et prendre des décisions que si au moins la moitié des gérants
est présente ou représentée dont toujours au moins un Gérant A et un Gérant B. Toute décision du Conseil de Gérance
doit être adoptée à l’unanimité des membres présents ou représentés.
Un ou plusieurs gérants peuvent participer à une réunion des gérants par conférence téléphonique ou par tout moyen
de communication similaire à partir du Luxembourg de telle sorte que plusieurs personnes pourront communiquer
simultanément. Cette participation sera réputée équivalente à une présence physique à la réunion. Cette décision pourra
être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même contenu et signés par tous
les membres y ayant participé.
Une décision écrite signée par tous les gérants sera aussi valable et effective que si elle avait été prise lors d’une réunion
du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue.
Cette décision pourra être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même
contenu et signés par tous les membres du Conseil de Gérance.
Le Conseil de Gérance pourra déléguer ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires
ad-hoc.
Le Conseil de Gérance déterminera la responsabilité du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de
la période de représentation et n’importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.
Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par la signature conjointe d’un Gérant A et d’un Gérant B ou par la signature
de tout mandataire désigné par le Conseil de Gérance, pourvu qu’il agisse dans le cadre des compétences fixées par le
Conseil de Gérance.
Art. 13. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux enga-
gements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 14. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés.
En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de
parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.
En cas de pluralité d’associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées
par des associés représentant plus de la moitié du capital social.
Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que par l’accord de la majorité
des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la loi du 10 août
1915, telle que modifiée.
Art. 15. La Société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six (6) ans.
Art. 16. L'année sociale de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année.
Art. 17. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le Conseil de gérance
dresse un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société.
183783
L
U X E M B O U R G
Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire et du bilan.
Art. 18. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amor-
tissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.
Le solde du bénéfice net est à la libre disposition de l’assemblée générale.
Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués sous réserve du respect des conditions suivantes:
1. Seul le Conseil de gérance est compétent pour décider de la distribution d’acomptes sur dividendes;
2. Il est établi un état comptable par le Conseil de gérance faisant apparaître que les fonds disponibles pour la distri-
bution sont suffisants;
3. Le montant à distribuer ne peut excéder le montant des résultats réalisés depuis la fin du dernier exercice dont les
comptes annuels ont été approuvés, augmenté des bénéfices reportés ainsi que des prélèvements effectués sur les réserves
disponibles a cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes à porter en réserves en vertu d’une obligation
légale ou statutaire.
Lorsque les acomptes excèdent le montant du dividende arrêté ultérieurement par l’assemblée générale, ils sont, dans
cette mesure, considérés comme un acompte à valoir sur le dividende suivant.
Art. 19. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 20. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales de
la loi du 10 août 1915.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2014.
<i>Souscription et libérationi>
Les Statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les seize mille huit cent soixante-quinze (16.875) parts sociales ont
été souscrites par l’associée unique, la société “Creganna Medical Technology Unlimited”, pré-désignée et représentée
comme dit ci-avant, et libérées entièrement par la souscriptrice prédite moyennant un versement en numéraire, de sorte
que la somme seize mille huit cent soixante-quinze dollars américains (16.875,- USD) se trouve dès à présent à la libre
disposition de la Société, ainsi qu'il en a été prouvé au notaire instrumentant par une attestation bancaire, qui le constate
expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare par les présentes avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 183
de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, et en confirme expressément l’accomplisse-
ment.
<i>Résolutions prises par l’associée uniquei>
La partie comparante pré-mentionnée, représentant l’intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions sui-
vantes en tant qu’associée unique:
1. Les membres du conseil de gérance sont au nombre de trois (3). Sont nommés membres du conseil de gérance
pour une durée indéterminée:
<i>Gérants A:i>
- Monsieur Zubair JAVEED né le 17 mai 1972 à Stockport (Royaume-Uni), résidant à 8 the Parklands, Clarinbridge,
County Galway (Irlande);
<i>Gérants B:i>
- Monsieur Quentin DE NEVE DE RODEN, né le 27 mai 1975 à Ixelles (Belgique), résidant professionnellement à 5,
rue Guillaume Kroll L-1882 Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg);
- Madame Ingrid MOINET, née le 5 décembre 1975 à Bastogne (Belgique), résidant professionnellement à 5, rue
Guillaume Kroll L-1882 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
Conformément à l’article 12 des statuts, la Société est valablement engagée par la signature conjointe d’un gérant A
et d’un gérant B.
2. La société suivante est nommée commissaire de la Société pour la revue des comptes annuels au 31 Décembre
2014:
La société anonyme “ERNST & YOUNG LUXEMBOURG”, ayant son siège social à L-5365 Munsbach, 7, rue Gabriel
Lippmann, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 88019.
3. Le siège social de la société est établi à L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
183784
L
U X E M B O U R G
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de mille euros.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais et le français, déclare par les présentes, qu'à la requête de la partie
comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même partie comparante,
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte au Mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire
par nom, prénom, état civil et domicile, ledit Mandataire a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: C. DOSTERT, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 20 novembre 2014. LAC/2014/54735. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.
Luxembourg, le 26 novembre 2014.
Référence de publication: 2014187467/363.
(140210485) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2014.
CHH Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 192.117.
STATUTES
In the year two thousand and fourteen, on the tenth day of the month of November;
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.
THERE APPEARED:
1) Mr. Felix FABER, Bachelor Arts in International Business, born on February 7
th
, 1990 in Luxembourg (Grand Duchy
of Luxembourg), professionally residing in L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt; and
2) Mr. François FABER, Bachelor Arts in International Business, born on November 23, 1988 in Luxembourg (Grand
Duchy of Luxembourg), professionally residing in L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
Said appearing parties have established as follows the Articles of Incorporation of a company to be organized between
themselves:
Art. 1. There is hereby formed a corporation (“société anonyme”) under the name of “CHH FINANCE S.A.’’.
The registered office is established in the municipality of Luxembourg.
If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered
office or easy communication between that office and foreign countries shall occur or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality
of the corporation which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg
corporation.
The corporation is established for an unlimited period.
Art. 2. The Company may make any transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests
in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the development of
such participating interests.
The Company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of
a portfolio consisting of any type of movable or immovable assets, securities and patents of whatever origin, participate
in the creation, the development and the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, un-
derwriting or by option to purchase and any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way
of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed these securities and patents.
The Company may borrow in any form whatever.
The Company may grant to the companies of the group or to its shareholders, any support, loans, advances or gua-
rantees, within the limits of the Law.
Within the limits of its activity, the Company can grant mortgage, contract loans, with or without guarantee, and stand
security for other persons or companies, within the limits of the concerning legal dispositions.
183785
L
U X E M B O U R G
The Company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly
or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote its development or extension.
Art. 3. The corporate capital is fixed at thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-), divided into three hundred ten (310)
shares with a par value of one hundred euro (EUR 100.-) each.
The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which Law
prescribes the registered form.
The corporation's shares may be created, at the owner's option, in certificates representing single shares or two or
more shares.
Should the corporate share capital be increased, the rights attached to the new shares will be the same as those enjoyed
by the old shares.
Art. 4. The company is managed by a board of directors of class A and class B. The number of directors is set to at
least three, shareholders or not.
The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be reeligible; they may be removed
at any time.
In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to provisionally fill the
vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.
The company commits to insuring each manager against losses, damages or expenses brought about by any legal action
or trial for which he/she could be held responsible in his/her present or past quality as manager of the company, except
in the case where through a similar action or trial, he/she is found guilty of grave negligence or intentional bad management.
Art. 5. The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corporation's
object. All matters not expressly reserved to the general meeting by Law or by the present Articles of Incorporation are
within the competence of the board of directors.
The board of directors may delegate all or part of its powers regarding the day-today management and the represen-
tation of the corporation in connection therewith to one or more directors, managers or other officers; they need not
be shareholders of the company.
The corporation is committed either by the individual signature of the delegate of the board of directors or by the
joint signatures of two directors, with at least the signature of one class A director and the signature of one class B
director, or by the joint or single signature of any person(s) to whom special signatory powers have been delegated by
the board of directors.
Art. 6. The board of directors may elect a chairman; in the absence of the chairman, any other director may preside
over the meeting.
The board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy
between directors, which may be given by letter, telegram, telex, telefax or e-mail, being permitted. In case of emergency,
directors may vote by letter, telegram, telex, telefax or e-mail.
The decisions of the board of directors are taken by a majority of directors present or represented, with at least the
presence or representation of one class B director.
The chairman of the board is appointed for the first time by the extraordinary general meeting.
Art. 7. The corporation shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be
appointed for a period not exceeding six years and they shall be reeligible; they may be removed at any time.
Art. 8. The corporation's financial year shall begin on the first day of January and shall end on the thirty-first day of
December of each year.
Art. 9. The annual general meeting of shareholders shall be held on the 2
nd
Friday of the month of June at 9:30 a.m.
at the registered office of the Company, or at such other place as may be specified in the notice of meeting.
If said day is a public holiday, the meeting shall be held the next following working day.
Art. 10. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the
shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to
their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.
The board of directors may decide that the shareholders desiring to attend the general meeting must deposit their
shares five clear days before the date fixed therefore. Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who
need not be a shareholder.
Each share gives the right to one vote.
Art. 11. The general meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may
concern the corporation.
It shall determine the appropriation and distribution of net profits.
183786
L
U X E M B O U R G
The board of directors is authorized to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by Law.
Art. 12. The Law of 10 August 1915 on Commercial Companies, as amended, shall apply in so far as these Articles of
Incorporation do not provide for the contrary.
<i>Transitory dispositioni>
The first fiscal year shall begin on the date of formation of the company and will end on the 31
st
December 2014.
<i>Subscription and paymenti>
The Articles of Incorporation having thus been established, the above-named parties have subscribed the shares as
follows:
1) Mr. Felix FABER, pre-named, one hundred fifty-five shares, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
2) Mr. François FABER, pre-named, one hundred fifty-five shares, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Total: three hundred ten shares, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
All these shares have been entirely paid up by payments in cash, so that the sum of thirty-one thousand euro (EUR
31,000.-) is forthwith at the free disposal of the corporation, as has been proved to the notary.
<i>Estimate of costsi>
The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the
corporation or which shall be charged to it in connection with its incorporation, at about one thousand Euro (EUR
1,000.-).
<i>Extraordinary general meeting:i>
Here and now, the above-named parties, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly
convened, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly constituted,
they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1. - The number of directors is set at five (5):
- The following persons are appointed as category A directors:
* H.E. Sheikh Hamad bin Jassim bin Jabr AL-THANI, businessman, born on 10 January 1959 in Qatar, residing in Doha
(QATAR), Al Wajba Palace, Dukhan Road, P.O. Box 4044; and
* H.E. Sheikh Jassim bin Hamad bin Jassim bin Jabr AL-THANI, corporate director, born 10 April 1982 in Qatar, residing
in Doha (QATAR), Al Wajba Palace, Dukhan Road, P.O. Box 4044 and;
- The following persons are appointed as category B directors:
* Mr. Jean FABER, chartered accountant, born on 26 October 1960 in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),
residing professionally in L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
* Mr. Felix FABER, Bachelor Arts in International Business, born on February 7
th
, 1990 in Luxembourg (Grand Duchy
of Luxembourg), professionally residing in L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt; and
* Mr. François FABER, Bachelor Arts in International Business, born on November 23, 1988 in Luxembourg (Grand
Duchy of Luxembourg), residing professionally in L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
The mandates of the directors shall expire immediately after the annual general meeting of the year 2020.
2. - The number of statutory auditors is set at one (1):
Is appointed statutory auditor:
“REVILUX S.A.’’, a Luxembourg joint stock company, having its registered office at L-2450 Luxembourg, 17, boulevard
Roosevelt, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 25549.
The mandate of the statutory auditor shall expire immediately after the annual general meeting of the year 2020.
3. - The registered office of the company is established in L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above
appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
persons, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the appearing persons, known to the notary by their name, first name, civil status
and residence, the said appearing persons have signed with Us, the notary, the present deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède
L'an deux mille quatorze, le dixième jour du mois de novembre;
183787
L
U X E M B O U R G
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné;
ONT COMPARU:
1) Monsieur Felix FABER, Bachelor Arts in International Business, né le 7 février 1990 à Luxembourg (Grand-Duché
de Luxembourg), demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt; et
2) Monsieur François FABER, Bachelor Arts in International Business, né le 23 novembre 1988 à Luxembourg (Grand-
Duché de Luxembourg), demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
Lesdits comparants ont arrêté, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme qu'ils vont constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de “CHH FINANCE S.A.’’.
Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet
sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la société est indéterminée.
Art. 2. La Société pourra effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-
cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
La Société pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et
à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous types d’actifs mobiliers ou immobiliers, de tous titres et brevets
de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport,
de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie
de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets.
La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit.
La Société pourra, dans les limites fixées par la Loi, accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous
concours, prêts, avances ou garanties.
Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter
caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.
La Société prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelcon-
ques, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent et qui sont susceptibles de
promouvoir son développement ou extension.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), divisé en trois cent dix (310) actions de cent
euros (EUR 100,-) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de plusieurs actions.
En cas d'augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent
les actions anciennes.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé d'administrateurs de catégorie A et d'administrateurs de
catégorie B. Le nombre des administrateurs est fixé à au moins trois, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
La société s'engage à indemniser tout administrateur des pertes, dommages ou dépenses occasionnés par toute action
ou procès par lequel il pourra être mis en cause en cause en sa qualité passée ou présente d'administrateur de la société,
sauf le cas ou dans pareille action ou procès, il sera finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise administration
intentionnelle.
Art. 5. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet
social; tout ce qui n'est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.
La société se trouve engagée, à l’égard des tiers, soit par la signature individuelle d'un administrateur-délégué, soit par
la signature conjointe de deux administrateurs, dont au moins la signature d'un administrateur de catégorie A et la
183788
L
U X E M B O U R G
signature d'un administrateur de catégorie B, soit par la signature conjointe ou unique de toute(s) personne(s) à qui des
pouvoirs de signature spéciaux ont été délégués par le conseil d'administration.
Art. 6. Le conseil d'administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la
réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat
entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique, étant admis. En
cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des administrateurs présents ou représentés, avec
au moins la présence ou la représentation d'un administrateur de catégorie B.
Pour la première fois, le président du conseil d'administration peut être nommé par l’assemblée générale extraordi-
naire.
Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra le 2
ème
vendredi du mois de juin à 09.30 heures au
siège social de la Société ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l’avis de convocation.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d'actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 11. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pre-
scrites par la loi.
Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures,
trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2014.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:
1) Monsieur Felix FABER, prénommé, cent cinquante-cinq actions, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
2) Monsieur François FABER, prénommé, cent cinquante-cinq actions, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Total: trois cent dix actions, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et
un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve à la disposition de la société, la preuve en ayant été rapportée au notaire qui le
constate.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de mille euros (EUR
1.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant, les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se considérant comme dûment
convoqués, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire et, après avoir constaté que celle-ci était régulière-
ment constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1. - Le nombre des administrateurs est fixé à cinq (5).
- Sont nommés administrateurs de catégorie A:
183789
L
U X E M B O U R G
* H.E. Sheikh Hamad bin Jassim bin Jabr AL-THANI, businessman, né le 10 janvier 1959 au Qatar, demeurant à Doha
(QATAR), Al Wajba Palace, Dukhan Road, P.O. Box 4044; et
* H.E. Sheikh Jassim bin Hamad bin Jassim bin Jabr AL-THANI, corporate director, né le 10 avril 1982 au Qatar,
demeurant à Doha (QATAR), Al Wajba Palace, Dukhan Road, P.O. Box 4044.
- Sont nommés administrateurs de catégorie B:
* Monsieur Jean FABER, expert-comptable, né le 26 octobre 1960 à Luxembourg, demeurant professionnellement à
L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt;
* Monsieur Felix FABER, Bachelor Arts in International Business, né le 7 février 1990 à Luxembourg (Grand-Duché
de Luxembourg), demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt; et
* Monsieur François FABER, Bachelor Arts in International Business, né le 23 novembre 1988 à Luxembourg (Grand-
Duché de Luxembourg), demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
Les mandats des administrateurs prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2020.
2. - Le nombre des commissaires aux comptes est fixé à un (1).
Est nommée commissaire aux comptes: “REVILUX S.A.’’, une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son
siège social à L-2450 Luxembourg, 17, boulevard Roosevelt, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Lu-
xembourg, sous le numéro B 25.549.
Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an
2020.
3. - Le siège social est établi à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais et le français, déclare par les présentes, qu'à la requête des
comparants le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes comparants, et en
cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états civils et domiciles, lesdits
comparants ont signé ensemble avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: F. FABER, F. FABER, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 13 novembre 2014. LAC/2014/53332. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
Luxembourg, le 26 novembre 2014.
Référence de publication: 2014187479/280.
(140210373) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2014.
Islazul Joint Venture S.à.r.l, Société à responsabilité limitée,
(anc. SHCO 99 S.à r.l.).
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 189.594.
In the year two thousand and fourteen, on the nineteenth day of the month of November.
Before us Maître Edouard DELOSCH, notary, residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
1. Islazul Joint Venture Feeder, a société en commandite spéciale, governed by the laws of Luxembourg, having its
registered office at L-2530 Luxembourg, 4a, rue Henri Schnadt, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the
Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B189. 594 (the “Shareholder”),
hereby represented by Mrs Julie INDENKLEEF, professionaly residing in Diekirch, by virtue of a proxy given on 18
November 2014.
The said proxy shall be annexed to the present deed.
The Shareholder has requested the undersigned notary to record that the Shareholder is the sole shareholder of
SHCO 99 S.à r.l., a société à responsabilité limitée, governed by the laws of Luxembourg, having a share capital of twelve
thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), with registered office at L-2530 Luxembourg, 4a rue Henri Schnadt, Gaspe-
rich, Grand Duchy of Luxembourg incorporated following a deed of Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster,
of 11 August 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2928 of 14 October 2014,
registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 189.594 (the "Company"). The
articles of incorporation of the Company have not been amended.
183790
L
U X E M B O U R G
The Shareholder, represented as above mentioned, having recognised to be duly and fully informed of the resolutions
to be taken on the basis of the following agenda:
<i>Agendai>
1 To change the name of the Company to “Islazul Joint Venture S.à r.l”.
2 To amend article 4 of the articles of incorporation of the Company so as to reflect the resolution to be adopted
under item 1.
3 Miscellaneous.
The Shareholder has requested the undersigned notary to record the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Shareholder resolved to change the name of the Company to “Islazul Joint Venture S.à r.l”.
<i>Second resolutioni>
The Shareholder resolved to amend article 4 of the articles of association of the Company which shall from now on
read as follows:
« Art. 4. The private limited liability company will assume the name of “Islazul Joint Venture S.à r.l”.»
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed
are estimated at one thousand euros (EUR 1.000,-).
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same party and in case of
divergences between the English and the French text, the English text will prevail.
Whereupon, the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the
beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, who is known to the undersigned notary
by his surname, first name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quatorze, le dix-neuvième jour du mois de novembre.
Par-devant nous Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
1. Islazul Joint Venture Feeder, une société en commandite spéciale, régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg,
ayant son siège social au L-2530 Luxembourg, 4a, rue Henri Schnadt, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 190.475 (l'«Associé»),
représentée par Madame Julie INDENKLEEF, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procu-
ration donnée le 18 novembre 2014.
La prédite procuration restera annexée au présent acte.
L'Associé a requis le notaire instrumentant d'acter que l'Associé est l'associé unique de SHCO 99 S.à r.l., une société
à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant un capital social de douze mille cinq cents (EUR 12.500.-),
dont le siège social est situé au L-2530 Luxembourg, 4a, rue Henri Schnadt, Gasperich, Grand-Duché du Luxembourg,
constituée suivant acte de Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster en date du 11 août 2014, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 2928 du 14 octobre 2014, immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 189.594 (la «Société»). Les statuts de la société n'ont pas
été modifiés.
L'Associé, représenté comme indiqué ci-avant, reconnaissant avoir été dûment et pleinement informé des décisions à
intervenir sur base de l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jouri>
1 Modification du nom de la Société en “Islazul Joint Venture S.à r.l”.
2 Modification de l'article 4 des statuts de la Société afin de refléter la résolution à être adoptée sous le point 1.
3 Divers.
L'Associé a requis le notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé a décidé de changer le nom de la Société en “Islazul Joint Venture S.à r.l”.
183791
L
U X E M B O U R G
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la première résolution, l'Associé a décidé de modifier l'article 4 des statuts de la Société qui sera dorénavant
rédigé comme suit:
« Art. 4. La société à responsabilité limitée prend la dénomination de “Islazul Joint Venture S.à r.l”.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués
à mille euros (EUR 1.000,-).
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande de la partie
comparante ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande de la
même partie comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire
soussigné par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec, le notaire soussigné, le présent acte.
Signé: J. INDENKLEEF, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 21 novembre 2014. Relation: DIE/2014/14902. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): THOLL.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Diekirch, le 25 novembre 2014.
Référence de publication: 2014185834/92.
(140209160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2014.
AIM SOFTWARE Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8070 Bertrange, 10A-10B, rue des Mérovingiens.
R.C.S. Luxembourg B 146.512.
AUSZUG
Änderung der Adresse eines Verwaltungsratmitglieds
Die Adresse vom Verwaltungsratmitglied von Herrn Martin BUCHBERGER ist ab heutigem Datum folgende:
Obholzstrasse 5b
CH-8500 Frauenfeld
Schweiz
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 26/11/2014.
Référence de publication: 2014187374/15.
(140210404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2014.
Andreus Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 4-6, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 165.435.
<i>Extrait des Résolutions de l'Associé Unique d'Andreus Properties S.à r.l. prises le 7 Novembre 2014i>
L'unique Associé d'Andreus Properties S.à r.l. (la "Société"), a décidé comme suit:
- de nommer Katarzyna Ciesielska, née le 20 Mai 1982 à Łódź, Pologne, avec adresse professionnelle au 4-6 Avenue
de la Gare, L-1610 Luxembourg, en qualité de Gérant de la société et ce avec effet au 24 Novembre 2014
Le Conseil de gérance se compose comme suit:
Rachel Hafedh
Katarzyna Ciesielska
Property and Finance Corporation S.à r.l.
Luxembourg, le 7 Novembre 2014.
Référence de publication: 2014187350/17.
(140210170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2014.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
183792
AIM SOFTWARE Luxembourg S.A.
Andreus Properties S.à r.l.
Broadstreet International Partners S.à r.l.
Broadstreet of Münsbach S.à r.l.
CHH Finance S.A.
Classifieds Azerbaijan S.C.Sp
E.RE.A.S. Finance S.C.A.
Financière Figaro II S.à r.l.
Fox Bar S.à r.l.
Garage Schneiders s.à r.l.
Greganna Luxembourg
Günter Mencher Soparfi S.à r.l.
HellermannTyton Beta S.à r.l.
Highland VII - PRI (2) S.à r.l.
Hydrus Luxco 2 S.à r.l
Ihr Schreiner S.A.
Immo Préitzerdaul S.à.r.l.
Islazul Joint Venture S.à.r.l
ITXC IP Holdings
Januaship Holding S.A.
La Gardenia Holding S.à r.l.
LK Invest S.A.
L.M.I. Reconstruction Luxembourg
Lumex Sàrl
MERCURY TECHNOLOGIES
Meubles d'Exception s.à r.l.
Meyer Bergman European Retail Partners I Holdings S.à r.l.
M & H Capital Management S.A., société de gestion de patrimoine familial, en abrégé SPF
Morisco International S.A.
Oil Field Partners S.A.
Oxford Street Capital 2 S.à r.l.
Passage s.à r.l.
Passage s.à r.l.
Privin S.A.
Privin S.A.
ProLogis UK IV S.à r.l.
Ragtime Investissements S.A.
Ravensbourne Ventures S.à r.l.
Ravensbourne Ventures S.à r.l.
Red Anchor Holdings S.à r.l.
Rolebased Solutions S.A.
Schneiders Finance SA
Serafim Holding S.A.
Serafim Holding S.A.
SHCO 99 S.à r.l.
SM Holdings S.A.
Springboard Finance Holdco S.à r.l.
Steel Invest & Finance (Luxembourg) S.A.