This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 3803
10 décembre 2014
SOMMAIRE
aeco atelier d'architecture . . . . . . . . . . . . . .
182503
Ageney S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182500
Albali Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182500
Al Dente S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182500
Alema S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182500
Alema S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182501
Alibaba Kebab Snack S. à r. l. . . . . . . . . . . .
182503
Alluxbau s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182503
Ambassador Investment Allocation S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182504
Atrium International S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
182506
Balmoral Land Luxembourg Sàrl . . . . . . . .
182504
Bash, Vreugne & Associés S.A. . . . . . . . . . .
182504
BB Fuel 04 S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182504
Bernard Galonnier Investment Partners
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182504
Binnopharm International S.à r.l. . . . . . . . .
182505
Boetie Propco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182543
Bridon SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182506
BV Capital Partners Luxemburg S.A. . . . .
182506
Carey S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182516
Comptoir Technique et Industriel S.A. . . .
182542
Confédération Européenne de Volley-Ball
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182524
CS Energies SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182542
Edam Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182514
Elbblick (Delta) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182511
Elbblick (Juliet) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182521
Elbblick (Kilo) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182518
Foodco Invest S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182539
HayFin Jade LuxCo 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
182541
HayFin Jade LuxCo 3 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
182541
Immobiliengesellschaft Edward Steichen
Building Kirchberg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
182541
JP Commercial IX S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
182542
Key Note S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182498
RP XIII S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182505
RP XII S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182505
RP XI S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182505
RP X S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182505
RT Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182506
SCI Schmideberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182509
Sotrilux Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182501
Sport Distribution & Events Lux S.à r.l. . .
182502
Stratcom S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182505
Superbricolux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182541
Supercell S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182542
Syan Corporate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182542
SynerMesh S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182510
TalkingBird S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182542
Tamweelview Listed Securities Holdings S.
à r. l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182502
TENZING-Partners . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182502
TèrémeR, Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182503
Thonex Villeneuve S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
182538
Tomipal S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182502
T.O.Summit S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182503
Valentin DIEDRICH S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
182502
Vanguard Topco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
182500
Van Neulen & Schmit S.A. . . . . . . . . . . . . . .
182498
Vence Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
182498
Veneluxe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182498
Venetie Ventures S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182498
Vitruvian II Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . .
182499
Westrich Gen S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182499
Wilsonart International Holdings S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182499
Winsun Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182499
Yellowstone S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182499
182497
L
U X E M B O U R G
Veneluxe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.
R.C.S. Luxembourg B 144.666.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014185886/10.
(140208858) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2014.
Venetie Ventures S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach.
R.C.S. Luxembourg B 136.679.
Le Bilan au 31 DECEMBRE 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Référence de publication: 2014185887/10.
(140209073) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2014.
Vence Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach.
R.C.S. Luxembourg B 108.858.
Le Bilan au 31 DECEMBRE 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Référence de publication: 2014185885/10.
(140209071) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2014.
Van Neulen & Schmit S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1651 Luxembourg, 17, avenue Guillaume.
R.C.S. Luxembourg B 157.762.
Les statuts coordonnés au 12 novembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014185883/10.
(140209342) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2014.
Key Note S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 131.219.
RECTIFICATIF
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
en date du 21 août 2014 sous la référence L140150178.
Ce dépôt est à remplacer par le dépôt suivant:
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 novembre 2014.
<i>Pour Key Note S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.
Référence de publication: 2014187671/16.
(140209846) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2014.
182498
L
U X E M B O U R G
Yellowstone S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 147.041.
Le bilan de la société au 31/12/2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2014185900/12.
(140209494) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2014.
Winsun Europe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 169.319.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 24 novembre 2014.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2014185894/12.
(140209326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2014.
Wilsonart International Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 2.184.363,00.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 170.992.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2014185893/10.
(140209622) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2014.
Westrich Gen S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.
R.C.S. Luxembourg B 102.816.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014185891/10.
(140209030) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2014.
Vitruvian II Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 454.500,00.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 184.359.
Les statuts coordonnés au 13 novembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014185881/10.
(140209487) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2014.
182499
L
U X E M B O U R G
Vanguard Topco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 182.965.
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 novembre 2014.
Référence de publication: 2014185880/10.
(140209210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2014.
Al Dente S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3898 Foetz, 166A, rue du Brill.
R.C.S. Luxembourg B 166.546.
Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
ACA – Atelier Comptable & Administratif S.A.
Signature
Référence de publication: 2014187376/12.
(140210297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2014.
Ageney S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 36.682.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Extrait sincère et conforme
AGENEY S.A.
Signature
Référence de publication: 2014187372/12.
(140210111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2014.
Albali Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 16A, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 120.859.
Les comptes annuels clos au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014187377/10.
(140210281) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2014.
Alema S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 69.615.
<i>Dépôt rectificatif du bilan qui a été déposé le 20 novembre 2014 avec comme numéro de référence de dépôt L140206903i>
Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014187378/10.
(140209780) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2014.
182500
L
U X E M B O U R G
Alema S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 69.615.
<i>Dépôt rectificatif du bilan qui a été déposé le 20 novembre 2014 avec comme numéro de référence de dépôt L140206902i>
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014187379/10.
(140209781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2014.
Sotrilux Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-5884 Howald, 304A, route de Thionville.
R.C.S. Luxembourg B 91.590.
L'an deux mille quatorze, le onze novembre,
Par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
A COMPARU
Monsieur Domenico Tria, agent immobilier, né à Luxembourg le 15 septembre 1974, demeurant à L-5823 Fentange,
32, op der Sterz (ci-après désigné comme l'«Associé Unique»).
Laquelle partie comparante est l'Associé unique de la Société à responsabilité limitée SOTRILUX S.à r.l., ayant son
siège social à 304A, route de Thionville, L-5884 Howald, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
section B sous le numéro 91590, constituée suivant acte reçu par Maître Camille MINES, notaire de résidence à Capellen,
Grand Duché de Luxembourg en date du 24 janvier 2003 publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Asso-
ciations (ci-après le «Mémorial C») numéro 292 du 19 mars 2003; et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière
fois suivant acte reçu par Maître Camille MINES, préqualifié, en date du 20 décembre 2007 publié au Mémorial C numéro
262 du 31 janvier 2008.
L'article 200-2 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 dans sa version coordonnée
(«Article 200-2») dispose qu'un associé unique d'une société à responsabilité limitée exercera les pouvoirs de l'assemblée
générale des associés de la Société et les décisions de l'associé unique seront documentées dans un procès-verbal ou
rédigées par écrit.
<i>Résolution uniquei>
L'Associé Unique décide de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle au 304A, route de Thionville,
L-5884 Howald pour l'établir au 26 rue de l'Industrie, L-8069 Bertange et de procéder à la modification subséquente de
l'article 2 des statuts qui se lira désormais comme suit:
« Art. 4. Le siège social est établi dans la commune de Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg.
[...]»
<i>Frais et dépensei>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
en raison du présent acte, sont estimés approximativement à la somme de huit cents euros (EUR 800,-).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: D. TRIA, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 13 novembre 2014. Relation: LAC/2014/53341. Reçu soixante-quinze euros (75,-
€).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande.
Luxembourg, le 25 novembre 2014.
Référence de publication: 2014185841/42.
(140209112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2014.
182501
L
U X E M B O U R G
Sport Distribution & Events Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9759 Knaphoscheid, 1, Am Dahl.
R.C.S. Luxembourg B 173.492.
Le bilan et l'annexe légale de l'exercice au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014185843/10.
(140209492) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2014.
Valentin DIEDRICH S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9167 Mertzig, 4, rue des Moulins.
R.C.S. Luxembourg B 167.178.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25/11/2014.
G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg
Référence de publication: 2014185879/12.
(140209498) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2014.
Tomipal S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 37.527.
Le bilan de la société au 31/12/2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2014185870/12.
(140209057) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2014.
TENZING-Partners, Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 119, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 128.590.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014185862/10.
(140208932) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2014.
Tamweelview Listed Securities Holdings S. à r. l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 13, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 101.235.
Les comptes annuels de la société Tamweelview Listed Securities Holdings S.à r.l. au 31/12/2013 ont été déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014185853/10.
(140209604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2014.
182502
L
U X E M B O U R G
TèrémeR, Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 5, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 92.540.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014185852/10.
(140209365) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2014.
Alibaba Kebab Snack S. à r. l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5612 Mondorf-les-Bains, 22, avenue Frantz Clement.
R.C.S. Luxembourg B 137.835.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014187380/10.
(140210350) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2014.
Alluxbau s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2167 Luxembourg, 34, rue des Muguets.
R.C.S. Luxembourg B 10.789.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Le gérancei>
Référence de publication: 2014187381/10.
(140209678) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2014.
aeco atelier d'architecture, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 119, rue de l'Alzette.
R.C.S. Luxembourg B 164.160.
Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
SOAK TRUST S.A.
Signature
Référence de publication: 2014187324/12.
(140209844) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2014.
T.O.Summit S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 60.499.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
T.O. SUMMIT S.A.
Signatures
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2014185850/12.
(140209500) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2014.
182503
L
U X E M B O U R G
Ambassador Investment Allocation S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 133.056.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014187347/10.
(140209746) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2014.
Bernard Galonnier Investment Partners S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5835 Alzingen, 2, Hondsbréck.
R.C.S. Luxembourg B 154.176.
La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Martine DECKER, notaire de résidence à Hesperange, en date
du 02 juillet 2010, publié au Mémorial C du 14 juillet 2010.
Les comptes annuels de la société au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
BGIP SA
Signature
Référence de publication: 2014187405/14.
(140210458) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2014.
Balmoral Land Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 139.210.
Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Référence de publication: 2014187418/10.
(140209841) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2014.
Bash, Vreugne & Associés S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 87.833.
Le bilan au 31/12/2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014187420/10.
(140210174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2014.
BB Fuel 04 S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3672 Kayl, 85, rue de Tétange.
R.C.S. Luxembourg B 100.380.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014187421/10.
(140210407) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2014.
182504
L
U X E M B O U R G
Binnopharm International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.
R.C.S. Luxembourg B 177.650.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014187427/10.
(140210413) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2014.
RP X S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 127.155.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014185808/10.
(140209550) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2014.
RP XI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 128.226.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014185809/10.
(140209013) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2014.
RP XII S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 128.206.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014185810/10.
(140208951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2014.
RP XIII S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 128.225.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014185811/10.
(140209561) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2014.
Stratcom S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6995 Rameldange, 2, Hannert de Kleppbeem.
R.C.S. Luxembourg B 57.894.
Les Comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
182505
L
U X E M B O U R G
Strassen, le 25/11/2014.
<i>Pour STRATCOM S.à r.l.
i>J. REUTER
Référence de publication: 2014185846/12.
(140209607) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2014.
Bridon SA, Société Anonyme.
Siège social: L-4940 Bascharage, 111-115, avenue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 165.653.
Le bilan au 31/12/2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bascharage, le 26 novembre 2014.
Référence de publication: 2014187434/10.
(140210248) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2014.
BV Capital Partners Luxemburg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 109.290.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 novembre 2014.
Pour extrait conforme
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2014187438/12.
(140210318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2014.
Atrium International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.
R.C.S. Luxembourg B 131.050.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 septembre 2014.
SG AUDIT SARL
Référence de publication: 2014187394/11.
(140209701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2014.
RT Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 49.928,96.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 32, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 181.336.
In the year two thousand and fourteen, on the thirteenth day of the month of October.
Before Us, Maître Francis KESSELER, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
1. Acaju Investments S.A, a public limited liability company (société anonyme) incorporated and existing under the laws
of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 127, rue de Mühlenbach, L-2168 Luxembourg and
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg)
under number B 56.820 (“Acaju”);
2. Coginvest S.A, a public limited liability company (société anonyme) incorporated and existing under the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 3A, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg and
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg)
under number B 37.294 (“Coginvest”);
182506
L
U X E M B O U R G
3. Share Investments S.A, a public limited liability company (société anonyme) incorporated and existing under the laws
of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 3A, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxem-
bourg) under number B 124.313 (“Share”);
4. MindGeek RK S.à r.l. a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing
under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 32, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 169.252 (“MindGeek RK”);
5. RK Holdings LLC, a Florida limited liability company, having its registered office at 705 Washington Avenue, Third
Floor, Miami Beach, FL 33139, United States of America, being registered under the number 90-0878130 (“RK Holdings”);
here represented by Mrs. Sofia Da Chao, employee, residing professionally in Esch-sur-Alzette, by virtue of proxies
established under private seal.
I. The said proxies, signed ne varietur by the proxyholder of the persons appearing and the undersigned notary, will
remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
II. The appearing parties declare being the shareholders (the “Shareholders”) of RT Holding S.à r.l., a private limited
liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg, having its registered office at 32, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 181.336, incorporated by a deed of the
Notary Francis Kesseler of 8 October 2013, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations under
number 3174, page 152310 on 13 December 2013 (the "Company").
III. The articles of association of the Company (the “Articles”) have been amended for the last time by a deed of the
Notary Francis Kesseler of 18 October 2013, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations under
number 3318, page 159229 on 30 December 2013.
IV. The appearing parties, duly represented, having recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on
the basis of the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Cancellation of the nominal value of the share Capital of the Company;
2. Conversion of the share capital of the Company on the basis of the foreign exchange rate (USD 0,7319) with effect
on 18 October 2013 EUR 36,543.- (thirty six thousand five hundred forty three Euro) to USD 49,928.96 (forty nine
thousand nine hundred twenty-eight US Dollars and ninety six cent) representing:
Amount in USD
Category of Shares
17,078.97 USD 125,001 Category A Shares
28,162.19 USD 206,119 Category B Shares
4,687.80 USD 34,310 Category C Shares
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49,928.96 USD
364,430 Shares
3. Amendment of Article 5 of the articles of association of the Company, as amended from time to time (the “Articles”)
in order to reflect the resolution to be adopted above;
4. Retroactive modification of the Company's first financial year which shall run from the date of the incorporation of
the Company to 31 December 2013; and
5. Miscellaneous.
The appearing parties have requested the undersigned notary to document the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Shareholders RESOLVE to cancel the par value of the Shares.
<i>Second resolutioni>
The Shareholders RESOLVE to convert the share capital of the Company on the basis of the foreign exchange rate
(USD 0,7319) with effect on 18 October 2013 EUR 36,543.- (thirty six thousand five hundred forty three Euro) to USD
49,928.96 (forty nine thousand nine hundred twenty-eight US Dollars and ninety six cent)
<i>Third resolutioni>
So as to reflect the above resolution, the Shareholders RESOLVE to amend Article 5. of the Articles which shall
forthwith read as follows:
“ Art. 5. The Company issued share capital is set at USD 49,928.96 (forty nine thousand nine hundred twenty-eight
US Dollars and ninety six cent) divided into 364,430 (three hundred and sixty four thousand, four hundred and thirty)
Shares, consisting of: 125,001 (one hundred and twenty-five thousand and one) CATEGORY A Shares, 206,119 (two
hundred and six thousand, one hundred and nineteen) CATEGORY B Shares and 34,310 (thirty four thousand, three
hundred and ten) CATEGORY C Shares, each without par value.”
182507
L
U X E M B O U R G
<i>Fourth resolutioni>
The Shareholders RESOLVE to retroactively modify the Company's first financial year which shall run from the date
of the incorporation of the Company to 31 December 2013.
<i>Declarationi>
Whereof, the present deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons, the
present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of divergences
between the English and the French text, the English text will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, who is known to the notary by his
surname, first name, civil status and residence, she signed together with Us notary this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quatorze, le treize octobre.
Par-devant Nous, Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.
ONT COMPARU:
1. Acaju Investments S.A, une société anonyme constituée et existant en vertu des lois du Grand-Duché de Luxem-
bourg, ayant son siège social au 127, rue de Mühlenbach, L-2168 Luxembourg et enregistrée auprès du registre de
commerce et des sociétés (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) sous le numéro B 56.820 ("Acaju");
2. Coginvest S.A, une société anonyme constituée et existant en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant
son siège social au 3A, du boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg et enregistrée auprès du registre de commerce
et sociétés (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) sous le numéro B 37.294 ("Coginvest");
3. Share Investments S.A, une société anonyme constituée et existant en vertu des lois du Grand-Duché de Luxem-
bourg, ayant son siège social au 3A, du boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg et enregistrée auprès du registre de
commerce et sociétés (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) sous le numéro B 124.313 ("Share");
4. MindGeek RK S.à r.l. une société à responsabilité limitée incorporée et existant en vertu des lois du Grand-Duché
de Luxembourg, ayant son siège social au 32, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg et enregistrée auprès du registre de
commerce et sociétés (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) sous le numéro B 169.252 («MindGeek
RK»);
5. RK Holdings LLC, une société à responsabilité limitée de droit de Floride, ayant son siège social au 705 Washington
Avenue, Third Floor, Miami Beach, FL 33139, Etat-Unis, enregistrée sous le numéro 90-0878130 (“RK Holdings”);
ici représentées par Mme. Sofia Da Chao, employée privée, résidant professionnellement à Esch-sur-Alzette, en vertu
de procurations données sous seing privé.
I. Lesdites procurations signées ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant resteront
annexées au présent acte pour être soumises aux fins d'enregistrement.
II. Les comparants déclarent être les associés (les «Associés») de RT Holding S.à r.l., une société à responsabilité limitée
constituée et existante selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 32, boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 181.336, constituée par acte du notaire Francis Kesseler en date du 8 octobre 2013, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 3174, page 152310 du 13 décembre 2013 (la «So-
ciété»).
III. Les statuts de la Société (les «Statuts») ont été modifiés pour la dernière fois par un acte du notaire Francis Kesseler
en date du 18 octobre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 3318, page
159229 du 30 décembre 2013.
IV. Les comparants, représentés comme mentionné ci-dessus, reconnaissent d'être entièrement informé des résolu-
tions à prendre sur base de l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Annulation de la valeur nominale des parts sociales du Capital Social de la Société;
2. Conversion du capital social de la société sur base du taux de change (USD 0,7319) avec effet au 18 octobre 2013
de EUR 36,543.-(trente-six mille cinq cent quarante-trois Euro) à USD 49, 928. 96.- (quarante-neuf mille neuf cent vingt-
huit US Dollars et quatre-vingt-seize cent):
Montant en USD
Catégories des Parts
Sociales
17,078.97 USD 125,001 Catégories A
28,162.19 USD 206,119 Catégories B
4,687.80 USD
34,310 Catégories C
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49,928.96 USD 364,430 Parts Sociales
182508
L
U X E M B O U R G
3. Modification de l'Article 5. des statuts de la Société (les «statuts»), de façon à y refléter les modifications décidées
sous le point 2. ci-dessus;
4. Modification rétroactive du premier exercice social de la société, qui court à compter de la date de la constitution
de la société et se termine le 31 décembre 2013, et
5. Divers.
Les parties comparantes ont requis le notaire instrumentant de prendre acte des résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les Associés DECIDENT d'annuler la valeur nominale des parts sociales du Capital Social de la Société.
<i>Deuxième résolutioni>
Les Associés DECIDENT de convertir le capital social de la Société sur base du taux de change (USD 0,7319) avec
effet au 18 octobre 2013 de EUR 36.543,- (trente-six mille cinq cent quarante-trois Euro) à USD 49.928,96 (quarante-
neuf mille neuf cent vingt-huit US Dollars et quatre-vingt-seize cents).
<i>Troisième résolutioni>
Afin de refléter les résolutions adoptées ci-dessus, les Associés DECIDENT de modifier l'Article 5 des Statuts qui aura
désormais la teneur suivante:
« Art. 5. Le capital émis de la Société est fixé à USD 49.928,96 (quarante-neuf mille neuf cent vingt-huit US Dollars et
quatre-vingt-seize cents) divisé en 364.430 (trois cent soixante-quatre mille quatre cent trente) Parts Sociales composées
de: 125.001 (cent vingt-cinq mille et une) Parts Sociales de CATÉGORIE A, 206.119 (deux cent six mille cent dix-neuf)
Parts Sociales CATÉGORIES B et 34.310 (trente-quatre mille trois cent dix) Parts Sociales CATÉGORIES C, toutes sans
valeur nominale.»
<i>Quatrième résolutioni>
Les Associés DECIDENT de modifier rétroactivement le premier exercice social qui court à compter de la date de la
Constitution de la société et se termine le 31 décembre 2013.
<i>Déclarationi>
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.
Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-
avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes comparants,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Lecture du présent acte fait et interprétation donnée au mandataire des comparants, connu du notaire instrumentant
par son nom, prénom usuel, état et demeure, ledit mandataire a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 15 octobre 2014. Relation: EAC/2014/13970. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. Halsdorf.
POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2014185813/164.
(140209051) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2014.
SCI Schmideberg, Société Civile.
Siège social: L-8422 Steinfort, 8, rue Collart.
R.C.S. Luxembourg E 2.253.
L’an deux mille quatorze, le dix novembre.
Par-devant Maître PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
- Monsieur René KIEFFER, né le 21 novembre 1946 à Luxembourg, numéro de matricule 1946/1121/155-95, demeurant
à L-8422 STEINFORT, 11 rue de Hobscheid;
- Monsieur Romain THILL, né le 11 mai 1957, numéro de matricule 1957/0511/230-62, demeurant à L-8381 KLEIN-
BETTINGEN, 44 rue de Steinfort;
<i>Assemblée générale extraordinairei>
les comparants étant les seuls associés de la société civile immobilière SCI SCHMIDEBERG, constituée suivant acte
reçu par Madame Jacqueline HANSEN-PEFFER, notaire de résidence à Capellen le 23 février 1990, publié au Mémorial
182509
L
U X E M B O U R G
C des sociétés et associations numéro 337 de l’année 1990, inscrite au registre de commerce sous le numéro E 2253, et
représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se considèrent
comme dûment convoqués et ont pris les résolutions suivantes:
<i>Ordre du jouri>
1. Dissolution de la Société et mise en liquidation de la Société;
2. Nomination de Monsieur René KIEFFER prénommé, comme liquidateur et détermination de ses pouvoirs;
3. Divers.
<i>Première résolutioni>
Conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée, les associés
décident la dissolution anticipée de la Société et prononcent sa mise en liquidation à compter de ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l’assemblée générale décide de nommer en qualité de liquidateur:
- Monsieur René KIEFFER, né le 21 novembre 1946 à Luxembourg, numéro de matricule 1946/1121/155-95, demeurant
à L-8422 STEINFORT, 11 rue Hobscheid;
- Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée.
Il peut accomplir tous les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation des actionnaires dans les cas
où elle est requise.
Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privi-
lèges, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées ou
hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.
Le liquidateur est dispensé de l’inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires
telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.
<i>Déclaration en matière de blanchiment d'argent et de financement du terrorismei>
Les parties, en application de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le finan-
cement du terrorisme portant transposition de la directive 2001/97/CE du Parlement Européen et du Conseil du 4
décembre 2001 modifiant la directive 91/308/CEE du Conseil relative à la prévention de l’utilisation du système financier
aux fins du blanchiment de capitaux, déclarent être les bénéficiaires réels de l’opération immobilière faisant l’objet des
présentes et certifient que les fonds/biens/droits ne proviennent ni du commerce de stupéfiants, ni d'une des infractions
visées à l’article 506-1 du Code Pénal luxembourgeois.
Rien d'autre n'étant à l’ordre du jour, l’assemblée a été clôturée.
DONT ACTE, fait et passé à Ettelbruck, en l’étude, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et
demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: René KIEFFER, Romain THILL, Pierre PROBST.
Enregistré à Diekirch, Le 12 novembre 2014. Relation: DIE/2014/14465. Reçu soixante-quinze euros 75,00.-€.
<i>Le Receveuri> (signé): Tholl.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande et aux fins de publication au Mémorial.
Ettelbruck, le 24 novembre 2014.
Référence de publication: 2014185829/57.
(140208936) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2014.
SynerMesh S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6834 Biwer, 7, Millescheck.
R.C.S. Luxembourg B 160.018.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014183794/9.
(140206077) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2014.
182510
L
U X E M B O U R G
Elbblick (Delta) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 127.070.
In the year two thousand fourteen, the seventeenth day of October,
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
There appeared
at an extraordinary general meeting of the sole shareholder (the “Meeting”) of Elbblick (Delta) S à r.l., a Luxembourg
private limited liability company (Société à Responsabilité Limitée) having its registered office at 15, rue Edward Steichen,
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B127070, having a share
capital of EUR 12,500, incorporated on 19 April 2007 pursuant to a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations - N° 1138 of 13 June 2007, page 54578. The articles of association of
the Company have never been amended since the incorporation of the Company.
- Elbblick (Luxembourg) S à r.l., a Luxembourg private limited liability company (Société à Responsabilité Limitée) having
its registered office at 15, rue Edward Steichen, Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register under the number B120644, having a share capital of EUR 12,500 (the “Sole Shareholder”)
here represented by Régis Galiotto, notary’s clerk, residing in Luxembourg, by virtue of proxy given under private
seal.
Such proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.
The Sole Shareholder, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. that all of the 500 (five hundred) shares in the Company having a nominal value of EUR 25 (twenty five) each,
representing the entire share capital of the Company of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro) are represented
at the Meeting, which is thus duly constituted and may validly deliberate and decide on all items of the agenda reproduced
hereinafter.
II. that the agenda of the Meeting is the following:
1. Waiver of the convening notice;
2. Approval of the pro forma accounts of the Company for the period from 1 January 2014 to the 31 August 2014
(the “Pro forma Accounts”);
3. Dissolution of the Company and decision to put the Company into voluntary liquidation (liquidation volontaire);
4. Appointment of the liquidator (liquidateur) in relation to the voluntary liquidation of the Company (the Liquidator);
5. Determination of the powers of the Liquidator and determination of the liquidation procedure of the Company;
and
6. Discharge (quitus) to the members of the board of managers of the Company for the performance of their respective
mandates; and
7. Delegation of authority.
The Sole Shareholder takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The entirety of the corporate share capital being represented at the present Meeting, the Sole Shareholder waives the
convening notice, the Sole Shareholder represented at the Meeting considering itself as duly convened and declaring itself
to have perfect knowledge of the agenda which was communicated to it in advance of the Meeting.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to approve the Pro forma Accounts substantially in the form attached hereto.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to dissolve with immediate effect the Company and to put the Company into voluntary
liquidation (liquidation volontaire).
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to appoint Fairland Property Limited, having its registered office at P.O. Box 957,
Offshore Incorporations Centre, Tortola, British Virgin Islands, as Liquidator of the Company.
182511
L
U X E M B O U R G
<i>Fifth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to confer on the Liquidator the broadest powers set forth in articles 144 et seq. of the
amended Luxembourg law on commercial companies dated 10 August 1915 (the Law).
The Sole Shareholder also resolves to instruct the Liquidator, to the best of its abilities and with regard to the cir-
cumstances, to realise all the assets and to pay the debts of the Company.
The Sole Shareholder further resolves that the Liquidator shall be entitled to execute all deeds and carry out all
operations in the name of the Company, including those referred to in article 145 of the Law, without the prior autho-
risation of the Sole Shareholder. The Liquidator may delegate its powers for specific defined operations or tasks to one
or several persons or entities, although it will retain sole responsibility for the operations and tasks so delegated.
The Sole Shareholder further resolves to empower and authorise the Liquidator, on behalf of the Company in liqui-
dation, to execute, deliver, and perform the obligations under, any agreement or document which is required for the
liquidation of the Company and the disposal of its assets.
The Sole Shareholder further resolves to empower and authorise the Liquidator to make, in its sole discretion, advance
payments in cash or in kind of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the Sole Shareholder, in accordance with
article 148 of the Law.
<i>Sixth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to give full discharge (quitus) to the members of the board of managers of the Company
for the performance of their respective mandates until the date hereof.
<i>Seventh resolutioni>
The Sole Shareholder finally resolves to grant power and authority to any employee of Vistra (Luxembourg) S.à r.l.,
each acting individually, in order to accomplish the filing of the necessary documents regarding the above-mentioned
resolutions with the Luxembourg Trade and Companies Register and the publication in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, and generally to perform anything else which might be necessary or useful for the accomplish-
ment of the above resolutions.
<i>Costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately one thousand four hundred Euros (1,400.- Euro).
There being no further business on the agenda, the Meeting is closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on the request of the appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appearing party,
in the case of any discrepancy between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party
signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quatorze, le dix-sept octobre,
Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire résidant à Luxembourg au Grand-Duché de Luxembourg,
A comparu
à l’assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) de l’associé unique de Elbblick (Delta) S.à r.l., une société à res-
ponsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 15 rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg,
immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 127070 et ayant un
capital social de 12.500 euros (la Société). La Société a été constituée le 19 avril 2007 en vertu d’un acte de Maître Jean-
Joseph Wagner, publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations - N° 1138 du 13 Juin 2007, page 54578.
Les statuts de la Société n’ont pas été modifiés depuis la constitution de la Société,
- Elbblick (Luxembourg) S à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au
15 rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 120644 et ayant un capital social de 12.500 euros (l’Associé Unique)
ci-après représentée par Régis Galiotto, clerc de notaire, de résidence professionnelle à Luxembourg, en vertu d’une
procuration donnée par acte sous seing privé.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et
par le notaire instrumentaire demeurera annexée au présent acte pour être enregistrée ensemble avec celui-ci.
L'Associé Unique, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
I. que les 500 (cinq cent) parts sociales ayant une valeur nominale de EUR25 (vingt-cinq) chacune, représentant l’in-
tégralité du capital social de la Société d'un montant de EUR 12.500 (douze mille cinq cent), sont dûment représentées
182512
L
U X E M B O U R G
à la présente Assemblée qui est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points de
l’ordre du jour reproduit ci-après;
II. que l’ordre du jour de l’Assemblée est libellé comme suit:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Approbation des comptes pro forma de la Société pour la période allant du 1
er
janvier 2014 jusqu'au 31 août 2014
(les Comptes Pro forma);
3. Dissolution de la Société et décision de mettre la Société en liquidation volontaire;
4. Nomination du liquidateur en vue de la liquidation volontaire de la Société (le Liquidateur);
5. Détermination des pouvoirs du Liquidateur et détermination de la procédure de mise en liquidation de la Société;
6. Décharge (quitus) accordé aux membres du conseil de gérance pour l’exercice de leurs mandats respectifs; et
7. Délégation de pouvoir.
Après délibération, l’Associé Unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à la présente Assemblée, l’Associé Unique décide de
renoncer aux formalités de convocation, l’Associé Unique représentée à la présente Assemblée se considère comme
dûment convoquée et déclare avoir une parfaite connaissance de l’ordre du jour qui lui a été communiquée par avance.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique décide d'approuver les Comptes Pro forma dans la forme annexée aux présentes.
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé Unique décide avec effet immédiat de procéder à la dissolution de la Société et de la mettre en liquidation
volontaire.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Associé Unique décide de nommer Fairland Property Limited, ayant son siège social au P.O. Box 957, Offshore
Incorporations Centre, Tortola, British Virgin Islands, en tant que Liquidateur.
<i>Cinquième résolutioni>
L'Associé Unique décide de conférer au Liquidateur les pouvoirs les plus étendus tels que stipulés dans les articles 144
et seq. de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée (la Loi).
L'Associé Unique décide également d'instruire le Liquidateur, dans la limite de ses capacités et selon les circonstances,
afin qu'il réalise l’ensemble des actifs et solde les dettes de la Société.
L'Associé Unique décide que le Liquidateur sera autorisé à signer tous actes et effectuer toutes opérations au nom de
la Société, y compris les actes et opérations stipulés dans l’article 145 de la Loi, sans autorisation préalable de l’assemblée
générale de l’Associé Unique. Le Liquidateur pourra déléguer ses pouvoirs pour des opérations spécifiques ou d'autres
tâches à une ou plusieurs personnes ou entités, tout en conservant seul la responsabilité des opérations et tâches ainsi
déléguées.
L'Associé Unique décide également de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur, pour le compte de la Société en
liquidation, afin qu'il exécute, délivre, et effectue toutes obligations relatives à tout contrat ou document requis pour la
liquidation de la Société et à la liquidation de ses actifs.
L'Associé Unique décide en outre de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur afin d'effectuer, à sa discrétion, tous
versements d'avances en numéraire ou en nature des boni de liquidation L'Associé Unique, conformément à l’article 148
de la Loi.
<i>Sixième résolutioni>
L'Associé Unique décide d'accorder décharge aux gérants de la Société pour l’exercice de leurs mandats respectifs
jusqu'à la date des présentes.
<i>Septième résolutioni>
L'Associé Unique décide, en outre, d'accorder pouvoir et autorité à tout employé de Vistra (Luxembourg) S.à r.l.,
chacun agissant individuellement, afin d'accomplir toutes formalités nécessaires auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés concernant les résolutions figurant ci-dessus; et, généralement, d'effectuer toutes autres opérations qui pour-
raient être nécessaires ou utiles pour l’accomplissement des résolutions figurant ci-dessus.
<i>Estimation des fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société ou
dont elle est responsable en conséquence du présent acte sont estimés approximativement à mille quatre cents Euros
(1.400.-EUR).
182513
L
U X E M B O U R G
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte a
été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergences
entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l’original
du présent acte.
Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 octobre 2014. Relation: LAC/2014/50002. Reçu douze euros (12.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 17 novembre 2014.
Référence de publication: 2014183342/170.
(140206129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2014.
Edam Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 124.348.
DISSOLUTION
In the year two thousand fourteen, on the fourth day of November.
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned;
THERE APPEARED:
GS Capital Partners VI Fund, L.P., a Delaware Limited Partnership with registered office at 1209, Orange Street,
Wilmington, USA - 19801 New Castle County, Delaware, USA, registered with the Secretary of State of Delaware under
number 4298631,
represented by Mrs. Priscillia SPINA, private employee, with professional address at 2, rue du Fossé, L-1536 Luxem-
bourg, Grand Duchy of Luxembourg in Luxembourg (the “Proxy”) acting as a special proxy of by virtue of a proxy under
private seal given on 20 October 2014 which, after having been signed “ne varietur” by the appearing party and the
undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
The appearing party, represented as aforesaid, is the sole shareholder (the “Sole Shareholder”), of “Edam Holding S.à
r.l.” having its registered office at 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with
the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 124.348, incorporated pursuant to a deed dated 19
January 2007 before the notary Me Paul FRIEDERS, then notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial C") number 647 dated 19 April 2007 (the “Company”).
The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time pursuant a deed of the notary Me
Paul FRIEDERS, prenamed, on 14 December 2007, published in the Mémorial C number 334 on 8 February 2008.
The appearing party, represented as aforesaid, declares that it has full knowledge of the articles of incorporation and
of the financial standing of the Company and decides to dissolve and liquidate the Company with immediate effect.
The subscribed share capital of the Company amounts currently to three million one hundred and seventy-seven
thousand two hundred and seventy-five Euros (EUR 3,177,275.-) represented by three million one hundred and seventy-
seven thousand two hundred and seventy-five (3,177,275) shares with a par value of one Euro (EUR 1.-) each.
Being the Sole Shareholder of the shares and liquidator of the Company the appearing party, represented as aforesaid,
declares that all assets have been realised, and property of all assets has been transferred to the sole shareholder that
any and all liabilities towards third parties known to the Company have been entirely paid or duly accounted for. Regarding
any eventual liability presently unknown to the Company and not paid until the date of dissolution, the Sole Shareholder,
irrevocably assumes the obligation to guarantee payment of any such liability, with the result that the liquidation of the
Company is to be considered closed.
The Sole Shareholder, represented as aforesaid, gives discharge to the members of the Board of Managers for their
mandates up to this date.
That the Sole shareholder, represented as aforesaid, declares that the dissolution and liquidation of the Company is
closed and that any registers of the Company recording the issuance of shares or any other securities shall be cancelled.
The corporate books and accounts of the Company will be kept for periods of five years at registered office of the
Company.
In order to perform all the formalities relating to the registrations, the publications, the cancellations, the filing and all
other formalities to be performed by virtue of the present deed, all powers are granted to the bearer of an authentic
copy. However, no confusion of assets and liabilities between the dissolved Company and the share capital of, or reim-
182514
L
U X E M B O U R G
bursement to the sole shareholder will be possible before the end of a period of thirty days (by analogy to the article 69
(2) of the law on commercial companies) from the day of publication and subject to the non-respect by any creditor of
the dissolved Company of the granting of guarantees.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is evaluated at approximately one thousand one
hundred Euro (EUR 1,100.-).
WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above
appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
party, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
After reading the present deed to the proxy-holder of the appearing party, acting as said before, known to the notary
by name, first name, civil status and residence, the said proxy-holder has signed with Us the notary the present deed.
Suit la version en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille quatorze, le quatre novembre.
Par devant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné;
A COMPARU:
GS Capital Partners VI Fund, L.P. est une Delaware Limited Partnership, ayant son siège social à 1209, Orange Street,
USA-19801 Wilmington, New Castle County, Delaware, USA, enregistrée auprès du Secretary of State of Delaware sous
le numéro 4298631;
ici représentée par Mme Priscillia SPINA, employée privée, ayant son adresse professionnelle au 2, rue du Fossé, L-1536
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (le «Mandataire») agissant en sa qualité de mandataire spécial en vertu d'une
procuration sous seing privé lui délivrée le 20 Octobre 2014, laquelle, après avoir été signée «ne varietur» par le Man-
dataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistré avec lui.
La comparante, représentée comme ci-avant, est la seule et unique associée («l’Associée Unique») de «Edam Holding
S.à r.l.», ayant son siège social au 2 rue du Fossé, L-1536 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès
du registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 124.348, constituée le 19 janvier 2007 selon
un acte passé par devant le notaire Me Paul FRIEDERS, alors notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial C») numéro 647 en date du 19 avril 2007 (la «Société»).
Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Me Paul FRIEDERS, prénommé,
le 14 décembre 2007, publié au Mémorial C numéro 334 en date du 8 février 2008.
Le capital social de la Société s'élève actuellement à trois million cent septante-sept mille deux cent septante-cinq
Euros (3,177,275.-EUR), représenté par trois million cent soixante-dix-sept mille deux cent soixante-quinze (3,177,275)
parts sociales ayant une valeur nominale de un Euro (1.-EUR) chacune.
En agissant en qualité de liquidateur de la Société, tant qu'en qualité d’Associée Unique, elle déclare que tous les passifs
connus de la société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés, par rapport à d’éventuels
passifs, actuellement inconnus de la société et non payés à l’heure actuelle, assumer irrévocablement l’obligation de les
payer. Tous les actifs ont été réalisés, que tous les actifs deviendront la propriété de l’Associée Unique, de sorte que la
liquidation de la société est à considérer comme clôturée.
Décharge pleine et entière est accordée par la comparante, représentée comme ci-avant, aux membres du Conseil de
Gérance pour l’exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.
L’Associée Unique, représentée comme ci-avant, déclare que la dissolution et liquidation de la Société sont clôturées
et que tous les registres de la Société relatifs à l’émission d’actions ou de tous autres titres seront annulés.
Les livres et comptes de la Société seront conservés pendant cinq (5) ans au siège social.
Pour l’accomplissement des formalités relatives aux transcriptions, publications, radiations, dépôts et autres formalités
à faire en vertu des présentes, tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition des présentes. Toutefois, aucune
confusion de patrimoine entre la Société dissoute et l’avoir social de ou remboursement à l’associée unique ne pourra
se faire avant le délai de trente jours (par analogie à l’article 69 (2) de la loi sur les sociétés commerciales) à compter de
la publication et sous réserve qu'aucun créancier de la Société présentement dissoute et liquidée n’aura exigé la consti-
tution de sûretés.
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, est évalué approximativement à mille cent euros (1.100,-
EUR).
182515
L
U X E M B O U R G
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête de la partie
comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même partie comparante,
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.
Après lecture du présent acte au mandataire la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par
nom, prénom, état civil et domicile, ledit mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: P. SPINA, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 11 novembre 2014. LAC/2014/52689. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Carole FRISING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.
Luxembourg, le 20 novembre 2014.
Référence de publication: 2014183339/111.
(140206512) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2014.
Carey S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 122.743.
In the year two thousand and fourteen.
On the fourteenth of November.
Before us Henri BECK, notary, residing in Echternach (Grand-Duchy of Luxembourg).
Was held
an extraordinary general meeting of the shareholders of the corporation CAREY S.A., having its registered office in
L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert, registered at the register of commerce and companies of Luxembourg,
under the number B 122.743 (NIN 2006 2234 904),
incorporated by deed established by the notary Paul DECKER, residing in Luxembourg, on December 8
th
, 2006,
published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Number 195 on February 16
th
, 2007 and which articles
of incorporation have been amended as follows:
- by deed of the same notary Paul DECKER on January 16
th
, 2007, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés
et Associations number 906 on May 18
th
, 2007,
- by deed of the undersigned notary on May 9
th
, 2008, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations
number 1388 on June 5
th
, 2008,
- by deed of the undersigned notary on September 19
th
, 2008, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et
Associations number 2467 on October 9
th
, 2008.
The corporate capital is set at five hundred thousand Euro (€ 500.000.-), divided into four hundred thousand (400.000)
shares with a par value of one Euro twenty-five Cents (€ 1,25) each.
The meeting is presided by Mr. Barry BLACK, private employee, professionally residing in L-2453 Luxembourg, 19,
rue Eugène Ruppert,
who appoints himself as scrutineer and who elects as secretary Ms Patricia CHAPELIER, private employee, professio-
nally residing in L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state that:
I.- The agenda of the meeting is the following:
Amendment of article 15 of the articles of incorporation to give it the following reading:
« Art. 15. Annual General Meeting. The annual general meeting shall be held at the registered office of the Company
or at such other place as may be specified in the notice convening the meeting on the last Friday of June each year at
11.00 a.m.
If such day is a public holiday, the meeting will be held on the previous business day.».
II. There has been established an attendance list, showing the shareholders present and represented and the number
of their shares, which, after being signed by the shareholders or their proxies and by the bureau of the meeting, will be
registered with this deed together with the proxies "ne varietur" by the proxy holders and the notary.
III. It appears from the attendance list, that all the shares are present or represented at the meeting, the meeting is
therefore regularly constituted and can validly deliberate on the agenda, of which the shareholders have been informed
by the meeting.
IV. After deliberation, the following resolution was unanimously taken:
182516
L
U X E M B O U R G
<i>Unique resolutioni>
The meeting decides to amend article 15 of the articles of incorporation to give it the following reading:
« Art. 15. Annual General Meeting. The annual general meeting shall be held at the registered office of the Company
or at such other place as may be specified in the notice convening the meeting on the last Friday of June each year at
11.00 a.m.
If such day is a public holiday, the meeting will be held on the previous business day.».
As nothing remains on the agenda, the president hereby calls the meeting closed.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French translation. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by names, Christian
names, civil status and residences the said persons signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille quatorze.
Le quatorze novembre.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).
S'est réunie
l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CAREY S.A., ayant son siège social à L-2453
Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro
B 122.743 (NIN 2006 2234 904),
constituée suivant acte reçu par le notaire Paul DECKER, de résidence à Luxembourg, en date du 8 décembre 2006,
publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 195 du 16 février 2007, et dont les statuts ont été
modifiés comme suit:
- suivant acte reçu par ledit notaire Paul DECKER en date du 16 janvier 2007, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés
et Associations numéro 906 du 18 mai 2007,
- suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 9 mai 2008, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et
Associations numéro 1388 du 5 juin 2008
- suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 19 septembre 2008, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés
et Associations numéro 2467 du 9 octobre 2008.
Le capital social est fixé à cinq cent mille Euros (€ 500.000.-), représenté par quatre cent mille (400.000) actions d'une
valeur nominale de un Euro vingt-cinq Cents (€ 1,25) chacune.
La séance est présidée par Monsieur Barry BLACK, employé privé, demeurant professionnellement à L-2453 Luxem-
bourg, 19, rue Eugène Ruppert,
qui se nomme lui-même comme scrutateur et qui désigne comme secrétaire Madame Patricia CHAPELIER, employée
privée, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
Le bureau étant ainsi constitué Monsieur le Président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:
I. L'ordre du jour est conçu comme suit:
Modification de l’article 15 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:
« Art. 15. Assemblée Générale Annuelle. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la Société ou à tel
autre endroit indiqué dans les avis de convocations le dernier vendredi du mois de juin chaque année à 11h00.
Si ce jour est un jour férié légal l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable précédent.».
II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d'actions
qu'ils détiennent, laquelle liste après avoir été signée par les membres du bureau et ne varietur par le notaire instrumentant
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
III. Il résulte de cette liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée. Dès lors
l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer, sur l’ordre du jour dont les actionnaires ont pris
connaissance avant la présente assemblée.
IV. Après délibération l’assemblée prend à l’unanimité la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L’assemblée générale décide de modifier l’article 15 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:
« Art. 15. Assemblée Générale Annuelle. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la Société ou à tel
autre endroit indiqué dans les avis de convocations le dernier vendredi du mois de juin chaque année à 11h00.
182517
L
U X E M B O U R G
Si ce jour est un jour férié légal l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable précédent.».
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour Monsieur le Président lève la séance.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants, le présent
acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction française. Sur demande des mêmes comparants, et en
cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite aux comparants de tout ce qui précède, ces derniers, tous connus du notaire instrumentant par
noms, prénoms, états et demeures, ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.
Signé: B. BLACK, P. CHAPELIER, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 18 novembre 2014. Relation: ECH/2014/2206. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): J.-M. MINY.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Echternach, le 20 novembre 2014.
Référence de publication: 2014183252/109.
(140206923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2014.
Elbblick (Kilo) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 127.069.
In the year two thousand fourteen, the seventeenth day of October,
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
There appeared
at an extraordinary general meeting of the sole shareholder (the “Meeting”) of Elbblick (Kilo) S à r.l., a Luxembourg
private limited liability company (Société à Responsabilité Limitée) having its registered office at 15, rue Edward Steichen,
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B127069, having a share
capital of EUR 12,500, incorporated on 19 April 2007 pursuant to a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations - N° 1146 of 13 June 2007, page 54997. The articles of association of
the Company have never been amended since the incorporation of the Company.
- Elbblick (Luxembourg) S à r.l., a Luxembourg private limited liability company (Société à Responsabilité Limitée) having
its registered office at 15, rue Edward Steichen, Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register under the number B120644, having a share capital of EUR 12,500 (the “Sole Shareholder”)
here represented by Régis Galiotto, notary’s clerk, residing in Luxembourg, by virtue of proxy given under private
seal.
Such proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.
The Sole Shareholder, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. that all of the 500 (five hundred) shares in the Company having a nominal value of EUR 25 (twenty five) each,
representing the entire share capital of the Company of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro) are represented
at the Meeting, which is thus duly constituted and may validly deliberate and decide on all items of the agenda reproduced
hereinafter.
II. that the agenda of the Meeting is the following:
1. Waiver of the convening notice;
2. Approval of the pro forma accounts of the Company for the period from 1 January 2014 to the 31 August 2014
(the “Pro forma Accounts”);
3. Dissolution of the Company and decision to put the Company into voluntary liquidation (liquidation volontaire);
4. Appointment of the liquidator (liquidateur) in relation to the voluntary liquidation of the Company (the Liquidator);
5. Determination of the powers of the Liquidator and determination of the liquidation procedure of the Company;
and
6. Discharge (quitus) to the members of the board of managers of the Company for the performance of their respective
mandates; and
7. Delegation of authority.
The Sole Shareholder takes the following resolutions:
182518
L
U X E M B O U R G
<i>First resolutioni>
The entirety of the corporate share capital being represented at the present Meeting, the Sole Shareholder waives the
convening notice, the Sole Shareholder represented at the Meeting considering itself as duly convened and declaring itself
to have perfect knowledge of the agenda which was communicated to it in advance of the Meeting.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to approve the Pro forma Accounts substantially in the form attached hereto.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to dissolve with immediate effect the Company and to put the Company into voluntary
liquidation (liquidation volontaire).
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to appoint Fairland Property Limited, having its registered office at P.O. Box 957,
Offshore Incorporations Centre, Tortola, British Virgin Islands, as Liquidator of the Company.
<i>Fifth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to confer on the Liquidator the broadest powers set forth in articles 144 et seq. of the
amended Luxembourg law on commercial companies dated 10 August 1915 (the Law).
The Sole Shareholder also resolves to instruct the Liquidator, to the best of its abilities and with regard to the cir-
cumstances, to realise all the assets and to pay the debts of the Company.
The Sole Shareholder further resolves that the Liquidator shall be entitled to execute all deeds and carry out all
operations in the name of the Company, including those referred to in article 145 of the Law, without the prior autho-
risation of the Sole Shareholder. The Liquidator may delegate its powers for specific defined operations or tasks to one
or several persons or entities, although it will retain sole responsibility for the operations and tasks so delegated.
The Sole Shareholder further resolves to empower and authorise the Liquidator, on behalf of the Company in liqui-
dation, to execute, deliver, and perform the obligations under, any agreement or document which is required for the
liquidation of the Company and the disposal of its assets.
The Sole Shareholder further resolves to empower and authorise the Liquidator to make, in its sole discretion, advance
payments in cash or in kind of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the Sole Shareholder, in accordance with
article 148 of the Law.
<i>Sixth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to give full discharge (quitus) to the members of the board of managers of the Company
for the performance of their respective mandates until the date hereof.
<i>Seventh resolutioni>
The Sole Shareholder finally resolves to grant power and authority to any employee of Vistra (Luxembourg) S.à r.l.,
each acting individually, in order to accomplish the filing of the necessary documents regarding the above-mentioned
resolutions with the Luxembourg Trade and Companies Register and the publication in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, and generally to perform anything else which might be necessary or useful for the accomplish-
ment of the above resolutions.
<i>Costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately one thousand four hundred Euros (1,400.- Euro).
There being no further business on the agenda, the Meeting is closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on the request of the appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appearing party,
in the case of any discrepancy between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party
signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quatorze, le dix-sept octobre,
Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire résidant à Luxembourg au Grand-Duché de Luxembourg,
A comparu
182519
L
U X E M B O U R G
à l’assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) de l’associé unique de Elbblick (Kilo) S.à r.l., une société à res-
ponsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 15 rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg,
immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 127069 et ayant un
capital social de 12.500 euros (la Société). La Société a été constituée le 19 avril 2007 en vertu d’un acte de Maître Jean-
Joseph Wagner, publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations - N° 1146 du 13 Juin 2007, page 54997.
Les statuts de la Société n’ont pas été modifiés depuis la constitution de la Société,
- Elbblick (Luxembourg) S à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au
15 rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 120644 et ayant un capital social de 12.500 euros (l’Associé Unique)
ci-après représentée par Régis Galiotto, clerc de notaire, de résidence professionnelle à Luxembourg, en vertu d’une
procuration donnée sous seing privé.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et
par le notaire instrumentaire demeurera annexée au présent acte pour être enregistrée ensemble avec celui-ci.
L'Associé Unique, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
I. que les 500 (cinq cent) parts sociales ayant une valeur nominale de EUR25 (vingt-cinq) chacune, représentant l’in-
tégralité du capital social de la Société d'un montant de EUR 12.500 (douze mille cinq cent), sont dûment représentées
à la présente Assemblée qui est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points de
l’ordre du jour reproduit ci-après;
II. que l’ordre du jour de l’Assemblée est libellé comme suit:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Approbation des comptes pro forma de la Société pour la période allant du 1
er
janvier 2014 jusqu'au 31 août 2014
(les Comptes Pro forma);
3. Dissolution de la Société et décision de mettre la Société en liquidation volontaire;
4. Nomination du liquidateur en vue de la liquidation volontaire de la Société (le Liquidateur);
5. Détermination des pouvoirs du Liquidateur et détermination de la procédure de mise en liquidation de la Société;
6. Décharge (quitus) accordé aux membres du conseil de gérance pour l’exercice de leurs mandats respectifs; et
7. Délégation de pouvoir.
Après délibération, l’Associé Unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à la présente Assemblée, l’Associé Unique décide de
renoncer aux formalités de convocation, l’Associé Unique représentée à la présente Assemblée se considère comme
dûment convoquée et déclare avoir une parfaite connaissance de l’ordre du jour qui lui a été communiquée par avance.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique décide d'approuver les Comptes Pro forma dans la forme annexée aux présentes.
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé Unique décide avec effet immédiat de procéder à la dissolution de la Société et de la mettre en liquidation
volontaire.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Associé Unique décide de nommer Fairland Property Limited, ayant son siège social au P.O. Box 957, Offshore
Incorporations Centre, Tortola, British Virgin Islands, en tant que Liquidateur.
<i>Cinquième résolutioni>
L'Associé Unique décide de conférer au Liquidateur les pouvoirs les plus étendus tels que stipulés dans les articles 144
et seq. de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée (la Loi).
L'Associé Unique décide également d'instruire le Liquidateur, dans la limite de ses capacités et selon les circonstances,
afin qu'il réalise l’ensemble des actifs et solde les dettes de la Société.
L'Associé Unique décide que le Liquidateur sera autorisé à signer tous actes et effectuer toutes opérations au nom de
la Société, y compris les actes et opérations stipulés dans l’article 145 de la Loi, sans autorisation préalable de l’assemblée
générale de l’Associé Unique. Le Liquidateur pourra déléguer ses pouvoirs pour des opérations spécifiques ou d'autres
tâches à une ou plusieurs personnes ou entités, tout en conservant seul la responsabilité des opérations et tâches ainsi
déléguées.
L'Associé Unique décide également de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur, pour le compte de la Société en
liquidation, afin qu'il exécute, délivre, et effectue toutes obligations relatives à tout contrat ou document requis pour la
liquidation de la Société et à la liquidation de ses actifs.
182520
L
U X E M B O U R G
L'Associé Unique décide en outre de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur afin d'effectuer, à sa discrétion, tous
versements d'avances en numéraire ou en nature des boni de liquidation L'Associé Unique, conformément à l’article 148
de la Loi.
<i>Sixième résolutioni>
L'Associé Unique décide d'accorder décharge aux gérants de la Société pour l’exercice de leurs mandats respectifs
jusqu'à la date des présentes.
<i>Septième résolutioni>
L'Associé Unique décide, en outre, d'accorder pouvoir et autorité à tout employé de Vistra (Luxembourg) S.à r.l.,
chacun agissant individuellement, afin d'accomplir toutes formalités nécessaires auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés concernant les résolutions figurant ci-dessus; et, généralement, d'effectuer toutes autres opérations qui pour-
raient être nécessaires ou utiles pour l’accomplissement des résolutions figurant ci-dessus.
<i>Estimation des fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société ou
dont elle est responsable en conséquence du présent acte sont estimés approximativement à mille quatre cents Euros
(1.400.-EUR).
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte a
été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergences
entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l’original
du présent acte.
Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 octobre 2014. Relation: LAC/2014/50012. Reçu douze euros (12.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 17 novembre 2014.
Référence de publication: 2014183350/170.
(140206318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2014.
Elbblick (Juliet) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 127.089.
In the year two thousand fourteen, the seventeenth day of October,
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
There appeared
at an extraordinary general meeting of the sole shareholder (the “Meeting”) of Elbblick (Juliet) S à r.l., a Luxembourg
private limited liability company (Société à Responsabilité Limitée) having its registered office at 15, rue Edward Steichen,
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B127089, having a share
capital of EUR 12,500, incorporated on 19 April 2007 pursuant to a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations - N° 1181 of 16 June 2007, page 56664. The articles of association of
the Company have never been amended since the incorporation of the Company.
- Elbblick (Luxembourg) S à r.l., a Luxembourg private limited liability company (Société à Responsabilité Limitée) having
its registered office at 15, rue Edward Steichen, Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register under the number B120644, having a share capital of EUR 12,500 (the “Sole Shareholder”)
here represented by Régis Galiotto, notary’s clerk, residing in Luxembourg, by virtue of proxy given under private
seal.
Such proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.
The Sole Shareholder, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. that all of the 500 (five hundred) shares in the Company having a nominal value of EUR 25 (twenty five) each,
representing the entire share capital of the Company of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro) are represented
182521
L
U X E M B O U R G
at the Meeting, which is thus duly constituted and may validly deliberate and decide on all items of the agenda reproduced
hereinafter.
II. that the agenda of the Meeting is the following:
1. Waiver of the convening notice;
2. Approval of the pro forma accounts of the Company for the period from 1 January 2014 to the 31 August 2014
(the “Pro forma Accounts”);
3. Dissolution of the Company and decision to put the Company into voluntary liquidation (liquidation volontaire);
4. Appointment of the liquidator (liquidateur) in relation to the voluntary liquidation of the Company (the Liquidator);
5. Determination of the powers of the Liquidator and determination of the liquidation procedure of the Company;
and
6. Discharge (quitus) to the members of the board of managers of the Company for the performance of their respective
mandates; and
7. Delegation of authority.
The Sole Shareholder takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The entirety of the corporate share capital being represented at the present Meeting, the Sole Shareholder waives the
convening notice, the Sole Shareholder represented at the Meeting considering itself as duly convened and declaring itself
to have perfect knowledge of the agenda which was communicated to it in advance of the Meeting.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to approve the Pro forma Accounts substantially in the form attached hereto.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to dissolve with immediate effect the Company and to put the Company into voluntary
liquidation (liquidation volontaire).
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to appoint Fairland Property Limited, having its registered office at P.O. Box 957,
Offshore Incorporations Centre, Tortola, British Virgin Islands, as Liquidator of the Company.
<i>Fifth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to confer on the Liquidator the broadest powers set forth in articles 144 et seq. of the
amended Luxembourg law on commercial companies dated 10 August 1915 (the Law).
The Sole Shareholder also resolves to instruct the Liquidator, to the best of its abilities and with regard to the cir-
cumstances, to realise all the assets and to pay the debts of the Company.
The Sole Shareholder further resolves that the Liquidator shall be entitled to execute all deeds and carry out all
operations in the name of the Company, including those referred to in article 145 of the Law, without the prior autho-
risation of the Sole Shareholder. The Liquidator may delegate its powers for specific defined operations or tasks to one
or several persons or entities, although it will retain sole responsibility for the operations and tasks so delegated.
The Sole Shareholder further resolves to empower and authorise the Liquidator, on behalf of the Company in liqui-
dation, to execute, deliver, and perform the obligations under, any agreement or document which is required for the
liquidation of the Company and the disposal of its assets.
The Sole Shareholder further resolves to empower and authorise the Liquidator to make, in its sole discretion, advance
payments in cash or in kind of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the Sole Shareholder, in accordance with
article 148 of the Law.
<i>Sixth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to give full discharge (quitus) to the members of the board of managers of the Company
for the performance of their respective mandates until the date hereof.
<i>Seventh resolutioni>
The Sole Shareholder finally resolves to grant power and authority to any employee of Vistra (Luxembourg) S.à r.l.,
each acting individually, in order to accomplish the filing of the necessary documents regarding the above-mentioned
resolutions with the Luxembourg Trade and Companies Register and the publication in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, and generally to perform anything else which might be necessary or useful for the accomplish-
ment of the above resolutions.
182522
L
U X E M B O U R G
<i>Costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately one thousand four hundred Euros (1,400.- Euro).
There being no further business on the agenda, the Meeting is closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on the request of the appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appearing party,
in the case of any discrepancy between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party
signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quatorze, le dix-sept octobre,
Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire résidant à Luxembourg au Grand-Duché de Luxembourg,
A comparu
à l’assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) de l’associé unique de Elbblick (Juliet) S.à r.l., une société à res-
ponsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 15 rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg,
immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 127089 et ayant un
capital social de 12.500 euros (la Société). La Société a été constituée le 19 avril 2007 en vertu d’un acte de Maître Jean-
Joseph Wagner, publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations - N° 1181 du 16 Juin 2007, page 56664.
Les statuts de la Société n’ont pas été modifiés depuis la constitution de la Société,
- Elbblick (Luxembourg) S à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au
15 rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 120644 et ayant un capital social de 12.500 euros (l’Associé Unique)
ci-après représentée par Régis Galiotto, clerc de notaire, de résidence professionnelle à Luxembourg, en vertu d’une
procuration donnée sous seing privé.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et
par le notaire instrumentaire demeurera annexée au présent acte pour être enregistrée ensemble avec celui-ci.
L'Associé Unique, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
I. que les 500 (cinq cent) parts sociales ayant une valeur nominale de EUR25 (vingt-cinq) chacune, représentant l’in-
tégralité du capital social de la Société d'un montant de EUR 12.500 (douze mille cinq cent), sont dûment représentées
à la présente Assemblée qui est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points de
l’ordre du jour reproduit ci-après;
II. que l’ordre du jour de l’Assemblée est libellé comme suit:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Approbation des comptes pro forma de la Société pour la période allant du 1
er
janvier 2014 jusqu'au 31 août 2014
(les Comptes Pro forma);
3. Dissolution de la Société et décision de mettre la Société en liquidation volontaire;
4. Nomination du liquidateur en vue de la liquidation volontaire de la Société (le Liquidateur);
5. Détermination des pouvoirs du Liquidateur et détermination de la procédure de mise en liquidation de la Société;
6. Décharge (quitus) accordé aux membres du conseil de gérance pour l’exercice de leurs mandats respectifs; et
7. Délégation de pouvoir.
Après délibération, l’Associé Unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à la présente Assemblée, l’Associé Unique décide de
renoncer aux formalités de convocation, l’Associé Unique représentée à la présente Assemblée se considère comme
dûment convoquée et déclare avoir une parfaite connaissance de l’ordre du jour qui lui a été communiquée par avance.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique décide d'approuver les Comptes Pro forma dans la forme annexée aux présentes.
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé Unique décide avec effet immédiat de procéder à la dissolution de la Société et de la mettre en liquidation
volontaire.
182523
L
U X E M B O U R G
<i>Quatrième résolutioni>
L'Associé Unique décide de nommer Fairland Property Limited, ayant son siège social au P.O. Box 957, Offshore
Incorporations Centre, Tortola, British Virgin Islands, en tant que Liquidateur.
<i>Cinquième résolutioni>
L'Associé Unique décide de conférer au Liquidateur les pouvoirs les plus étendus tels que stipulés dans les articles 144
et seq. de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée (la Loi).
L'Associé Unique décide également d'instruire le Liquidateur, dans la limite de ses capacités et selon les circonstances,
afin qu'il réalise l’ensemble des actifs et solde les dettes de la Société.
L'Associé Unique décide que le Liquidateur sera autorisé à signer tous actes et effectuer toutes opérations au nom de
la Société, y compris les actes et opérations stipulés dans l’article 145 de la Loi, sans autorisation préalable de l’assemblée
générale de l’Associé Unique. Le Liquidateur pourra déléguer ses pouvoirs pour des opérations spécifiques ou d'autres
tâches à une ou plusieurs personnes ou entités, tout en conservant seul la responsabilité des opérations et tâches ainsi
déléguées.
L'Associé Unique décide également de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur, pour le compte de la Société en
liquidation, afin qu'il exécute, délivre, et effectue toutes obligations relatives à tout contrat ou document requis pour la
liquidation de la Société et à la liquidation de ses actifs.
L'Associé Unique décide en outre de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur afin d'effectuer, à sa discrétion, tous
versements d'avances en numéraire ou en nature des boni de liquidation L'Associé Unique, conformément à l’article 148
de la Loi.
<i>Sixième résolutioni>
L'Associé Unique décide d'accorder décharge aux gérants de la Société pour l’exercice de leurs mandats respectifs
jusqu'à la date des présentes.
<i>Septième résolutioni>
L'Associé Unique décide, en outre, d'accorder pouvoir et autorité à tout employé de Vistra (Luxembourg) S.à r.l.,
chacun agissant individuellement, afin d'accomplir toutes formalités nécessaires auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés concernant les résolutions figurant ci-dessus; et, généralement, d'effectuer toutes autres opérations qui pour-
raient être nécessaires ou utiles pour l’accomplissement des résolutions figurant ci-dessus.
<i>Estimation des fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société ou
dont elle est responsable en conséquence du présent acte sont estimés approximativement à mille quatre cents Euros
(1.400.-EUR).
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte a
été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergences
entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l’original
du présent acte.
Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 octobre 2014. Relation: LAC/2014/50011. Reçu douze euros (12.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 17 novembre 2014.
Référence de publication: 2014183349/170.
(140206315) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2014.
Confédération Européenne de Volley-Ball, Association sans but lucratif.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 488, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg F 1.135.
STATUTS
Art. 1
er
. Généralités, Autorité, Siège social, Langues.
Art. 1.1. La "CONFÉDÉRATION EUROPÉENNE DE VOLLEYBALL" (CEV) a.s.b.l. est l’association des fédérations
nationales, affiliées à la FIVB, dont la liste est établie en vertu de la zone géographique définie à l’art. 1.2.
182524
L
U X E M B O U R G
Art. 1.2. La CEV est le seul représentant de la FIVB dans la zone géographique qui lui est dévolue par celle-ci.
La CEV est représentée au Conseil d’Administration de la FIVB selon les modalités exposées dans l’article 5.9 ci-après
et au Chapitre 6 du Règlement Général de la CEV.
Art. 1.3. Les fédérations nationales ont l’obligation de respecter la constitution et/ou les Statuts, les règlements, les
règles de jeu et les décisions de la FIVB et de la CEV. Cette obligation s'étend également aux membres de ces fédérations,
incluant clubs, officiels, personnel assistant, arbitres, joueurs, entraîneurs, membres d’équipes et toute personne agissant
dans le cadre de leur responsabilité en respect de leurs statuts et règlements.
Art. 1.4. Le siège de la CEV est établi à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
Art. 1.5. Les langues officielles sont:
- l’anglais
- le français
La langue d’usage officielle est l’anglais. Tous avis officiels et toute correspondance doivent se faire en anglais. En cas
de conflits ou disputes concernant l’interprétation entre les textes établis dans les deux langues, le texte anglais fera loi.
Les statuts et autre documents légaux doivent être rédigés en anglais et en français selon la loi luxembourgeoise régissant
les associations sans but lucratif.
Art. 1.6. L'association est constituée pour une durée indéterminée et est reconnue par la FIVB.
Art. 2. Objectifs & Tâches. La CEV poursuit, dans la zone géographique qui lui est dévolue, les objectifs de la FIVB afin
d’encourager le développement et la croissance de la pratique du volley-ball dans toutes ses formes, comme énumérés
à l’article 1.4 de la Constitution de celle-ci, avec un accent tout particulier sur les aspects ci-après:
Art. 2.1 . Coordonner l’activité des fédérations nationales afin de promouvoir une coopération mutuelle et une bonne
entente entre elles et aplanir tout conflit éventuel.
Art. 2.2. Favoriser le développement des relations amicales entre les fédérations nationales, les officiels, entraîneurs,
arbitres et joueurs.
Art. 2.3. Veiller au respect de la Constitution de la FIVB, du Code de Conduite, des Règlements, des Règles Officielles
et des décisions de la FIVB.
Art. 2.4. Promouvoir l’expansion et la popularité du volley-ball dans toutes ses formes.
Art. 2.5. Encourager la constitution de fédérations nationales et leur affiliation à la FIVB.
Art. 2.6. Organiser les Championnats Continentaux et toutes autres compétitions officielles.
Art. 2.7. Etablir le calendrier des rencontres internationales et en informer le Conseil des Evénements Sportifs de la
FIVB.
Art. 2.8. Éveiller l’intérêt des pouvoirs publics pour le volley-ball.
Art. 2.9. Encourager l’organisation de cours et de stages de perfectionnement, tant dans le domaine technique que
celui de l’arbitrage.
Art. 2.10. Assurer l’amélioration du matériel et des équipements sportifs
Art. 3. Affiliation.
Art. 3.1. Le nombre minimum de fédérations nationales affiliées s'élève à trois.
Art. 3.2. Une Fédération Nationale peut devenir un membre de la CEV après avoir complété le processus d’affiliation
à la FIVB et en respect des décisions de l’Assemblée Générale de la CEV.
Toute demande d'affiliation sera soumise par écrit au Conseil d'Administration.
Pareille demande écrite implique l’acceptation inconditionnelle des Statuts, du Règlement Général et des décisions de
la CEV.
Art. 3.3. Toute fédération peut, à tout moment, quitter l’association, pour autant qu'elle ait satisfait à l’ensemble de
ses obligations financières.
Toute démission sera notifiée par lettre recommandée adressée au Conseil d'Administration.
Seule l’Assemblée Générale est habilitée à exclure un membre de l’association, à condition toutefois qu'une telle
décision recueille les deux tiers des voix et que le membre effectif en question ait été entendu préalablement.
Art. 4. Institutions.
Art. 4.1. Les institutions de la CEV
4.1.1 L’Assemblée Générale.
4.1.2 Le Conseil d’Administration.
182525
L
U X E M B O U R G
4.1.3 Le Comité Exécutif.
4.1.4 Les Commissions. Les Vérificateurs aux Compte
Art. 4.2. La Chambre de Médiation.
Art. 4.3. Les Groupes de Travail.
Art. 4.4. Le Secrétariat.
Art. 4.5. Limite d’âge pour les Officiels de la CEV
En accord avec l’article 2.1.4 de la Constitution de la FIVB, une limite d’âge de 75 ans est fixée pour tous les officiels
de la CEV, élus ou nommés à un quelconque poste à responsabilité au sein de la CEV. Cette limite d’âge prend effet au
31 décembre de l’année calendrier durant laquelle l’âge limite est atteint ou au plus tard à la fin du mandat des officiels.
Art. 5. Assemblée générale.
Art. 5.1. L'Assemblée Générale des fédérations nationales affiliées, conformément à l’art. 3.2 des présents statuts,
constitue l’autorité suprême de celle-ci. Ses décisions revêtent un caractère contraignant et exécutoire à l’égard des
propres institutions de la CEV et des fédérations nationales.
Art. 5.2. L'Assemblée Générale est composée des délégués accrédités à cette fin par les fédérations affiliées. Ne peuvent
participer aux Assemblées Générales que les délégués des fédérations qui sont en ordre avec la CEV quant au respect
de leurs obligations et engagements financiers.
Les délégués exclus de la participation pourront assister aux Assemblées Générales sans droit de parole ou de vote.
L'Assemblée Générale est ouverte lorsque les deux tiers au moins des fédérations ayant droit de participation sont
présents ou s'y sont fait représenter.
Art. 5.3. Chaque fédération affiliée peut accréditer deux délégués au maximum.
Les délégués accrédités doivent être membres de la fédération concernée ou posséder la nationalité du pays intéressé.
Les membres du Conseil d’Administration en fonction ne peuvent pas être accrédités en qualité de délégués de leur
fédération.
Les noms des délégués sont repris sur un document d'accréditation qui leur donne pouvoir de délibérer et les classe
par ordre de préséance. Ce document est signé par le Président et le Secrétaire Général de la fédération concernée et
revêtu du sceau officiel de celle-ci. Il doit être remis au Secrétariat de l’Assemblée Générale avant l’ouverture de celle-
ci.
Art. 5.4. Toute fédération affiliée peut se faire représenter par les délégués accrédités d'une autre fédération affiliée.
Les délégués accrédités par une fédération affiliée ne peuvent représenter plus d'une autre fédération affiliée. Le pouvoir
de représentation est repris sur un document désignant la fédération affiliée dont les délégués accrédités seront les
mandataires. Ce document est signé par le Président et le Secrétaire Général de la fédération représentée et revêtu du
sceau officiel de celle-ci. Il doit être remis au Secrétariat avant l’ouverture de l’Assemblée Générale.
Art. 5.5. Les délégués disposent d'une voix par fédération qu'ils représentent conformément à l’article 5.4.
Art. 5.6. La validité des documents dont question à l’article 5.3 et 5.4 est contrôlée par une Commission de Vérification
des Pouvoirs désignée par l’Assemblée Générale. Les votes n'ont lieu qu'après présentation du rapport de la dite Com-
mission.
Art. 5.7. La Commission de Vérification des Pouvoirs comprend quatre membres.
Art. 5.8. L'Assemblée Générale se réunit chaque année en session ordinaire. L'Assemblée Générale est seule habilitée
à déroger à cette règle pour l’année à venir.
Les conditions pour l’organisation d’une Assemblée Générale sont définies dans le Règlement Général de la CEV.
Art. 5.9. La date et le lieu de l’Assemblée Générale seront notifiés aux fédérations nationales moyennant un préavis
d'au moins six mois.
En accord avec l’article 2.4.1.2 de la Constitution de la FIVB, la CEV doit, l’année précédant les Jeux Olympiques d’été,
organiser son Assemblée Générale fin d’élire ses membres au Conseil d’Administration de la FIVB, y compris le Président
de la CEV, tel que notifié au chapitre VI du Règlement Général.
Art. 5.10. Seules les deux langues officielles de la CEV sont utilisées aux séances de l’Assemblée Générale. Si nécessaire,
les fédérations nationales prennent leurs dispositions pour s'assurer l’aide d'un interprète.
Les documents officiels présentés pendant l’Assemblée Générale seront uniquement diffusés en anglais; ils feront l’objet
d’une traduction simultanée en français à chaque fois que cela s’avère opportun.
Art. 5.11. Toutes propositions qu'une fédération nationale désire soumettre à l’Assemblée Générale sont adressées,
par écrit, au Secrétariat au plus tard quatre mois avant la date d'ouverture de l’Assemblée Générale.
182526
L
U X E M B O U R G
Les propositions de modifications aux statuts font l’objet d'un examen par la Commission Juridique, qui fera rapport
au Conseil d’Administration et à l’Assemblée Générale. Cette Commission est habilitée à suggérer une nouvelle rédaction
des textes, le fond devant rester conforme à la proposition.
Art. 5.12. Les candidatures aux postes vacants des organes de la CEV seront introduites par écrit par les fédérations
nationales et envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception au Secrétariat au plus tard trois mois avant la
date d'ouverture de l’Assemblée Générale.
Le délai indiqué au paragraphe précédent ne s'applique pas au cas prévus par l’art. 6.3.
Chaque fédération nationale ne peut présenter qu'un seul candidat par organe de la CEV.
La présentation d'un candidat implique l’engagement de la fédération de supporter les frais de transport et d'héber-
gement relatifs aux réunions auxquelles le candidat devra assister après son élection ou désignation.
Art. 5.13. L’ordre du jour sera envoyé aux fédérations nationales au moins trois mois avant la date d'ouverture de
l’Assemblée Générale.
Seules les questions figurant à l’ordre du jour seront discutées.
Pour des raisons d'urgence, des questions ne figurant pas à l’ordre du jour pourront être discutées à la condition que
l’Assemblée Générale en ait décidé à la majorité des deux tiers des voix ayant participé au vote.
Les points repris ci-après figurent obligatoirement à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale ordinaire:
a) Allocution d'ouverture du Président;
b) Mise en place du Bureau;
c) Rapport de la commission des vérificateurs des pouvoirs;
d) Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale précédente;
e) Présentation et adoption des rapports d'activité de la CEV;
f) Présentation du rapport financier;
g) Rapport des vérificateurs aux comptes;
h) Discussion et approbation des comptes;
i) Discussion et approbation des programmes d'activité et du budget;
j) Présentation des rapports de commissions;
k) Vote des propositions introduites conformément à l’article 5.11;
l) Élections statutaires;
m) Questions diverses;
n) Discours de clôture du Président
Art. 5.14. L'Assemblée Générale se réunit en session extraordinaire sur décision du Conseil d'Administration ou à la
demande du tiers au moins des fédérations nationales. En pareil cas, elles sont avisées trois mois à l’avance au moins de
la date, du lieu et de l’ordre du jour.
Art. 5.15. Les votes ont lieu à main levée et les décisions sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés, sauf
les exceptions prévues par les présents statuts.
Le vote est effectué par appel nominal sur décision du Président lorsque le vote à main levée manque de clarté, ou à
la demande de cinq fédérations nationales. Le vote a lieu dans l’ordre alphabétique des pays représentés.
Les décisions sont adoptées à la majorité absolue, c'est-à-dire, lorsqu'elles recueillent plus de la moitié des voix ayant
participé au vote.
Les votes concernant les personnes sont effectués au bulletin secret. Sont élus, au premier tour, les candidats ayant
obtenu la majorité absolue; au second tour, ceux qui obtiennent le plus de voi.x. En cas d'égalité de voix, un vote dépar-
tagera les candidats en ballotage.
Les statuts sont modifiés à la majorité des deux tiers au moins des voix.
Deux tiers des membres effectifs doivent être présents ou s'être fait représenter.
Art. 5.16. Les procès-verbaux de l’Assemblée Générale sont établis par le Secrétariat de la CEV dans les deux langues
officielles de la CEV. En cas de contestation au sujet de l’interprétation de ces procès-verbaux, le texte anglais fera foi.
Les procès-verbaux de l’Assemblée Générale sont adressés aux fédérations nationales dans les trois mois suivant la
clôture de l’Assemblée Générale: ils peuvent être consultés au siège social de la Confédération et sont publiés dans
l’organe officiel de la CEV.
Ils sont approuvés provisoirement par le Conseil d'Administration et, définitivement, par l’Assemblée Générale sui-
vante.
Art. 5.17. L'Assemblée Générale peut, sur proposition du Conseil d'Administration, accorder des titres honorifiques
de Président, Vice-Président ou Membre d'Honneur aux personnes ayant respectivement tenu ces postes et à toute
personne ayant fait preuve de mérites exceptionnels au profit de la CEV.
182527
L
U X E M B O U R G
Art. 5.18. Sauf si l’Assemblée Générale en décide autrement, ses décisions devraient entrer en vigueur immédiatement.
Toutes les décisions seront également notifiées par écrit aux fédérations nationales dans un délai de 30 jours suivant
la date de clôture de l’Assemblée Générale.
Art. 6. Conseil d'administration.
Art. 6.1. Le Conseil d'Administration est composé de 17 membres (incluant le Président) élus par l’Assemblée Géné-
rale.
Parmi les membres élus doivent figurer au moins deux personnes de chaque genre. Si seuls des candidats du même
genre sont élus parmi les 17, seuls les 15 premiers (incluant le Président) sont déclarés élus et les autres seront les 2
candidats du genre minoritaire qui auront obtenu le plus grand nombre de voix. Dans le cas où seul un candidat du genre
minoritaire est élu parmi les 17, seuls les 16 premiers (incluant le Président) sont déclarés élus et le dernier sera le candidat
du genre minoritaire qui aura obtenu le plus grand nombre de voix. Dans le cas où il n’y a pas suffisamment de candidats,
le Conseil d’Administration sera complété à l’occasion d’une élection supplémentaire lors de la prochaine Assemblée
Générale.
La fonction de Président de la Commission Financière sera assumée par le Vice-président exerçant la charge de Tré-
sorier conformément aux dispositions prévues à l’article 6.7.
Art. 6.2. Les candidatures pour le Conseil d'Administration devront être présentées conformément aux dispositions
de l’Art. 5.12.
Art. 6.3. La durée du mandat du Conseil d’Administration est de quatre ans, jusqu’à l’Assemblée Générale de la
quatrième année après l’année des élections. Si l’un d'eux est dans l’impossibilité définitive d'exercer son mandat, il ne
sera pas remplacé jusqu'à la prochaine Assemblée Générale En pareil cas, toutes les fédérations nationales seront im-
médiatement avisées d'une telle démission et recevront les directives appropriées concernant la procédure de rempla-
cement à mettre en oeuvre lors de la toute prochaine Assemblée Générale
En pareil cas, toutes les fédérations nationales seront immédiatement avisées d'une telle démission et recevront les
directives appropriées concernant la procédure de remplacement à mettre en oeuvre lors de la toute prochaine Assem-
blée Générale.
Toute démission notifiée à la CEV dans un délai inférieur à 2 mois avant l’Assemblée Générale ne fera pas l’objet d'une
procédure de remplacement avant la session suivante de l’Assemblée Générale
Toute démission notifiée à la CEV dans un délai inférieur à 2 mois avant l’Assemblée Générale ne fera pas l’objet d'une
procédure de remplacement avant la session suivante de l’Assemblée Générale.
Toute élection supplémentaire d’un membre du Conseil d’Administration prendra effet pour la période du mandat
restant
Art. 6.4. En cas d'absence temporaire ou fortuite, les membres directement élus du Conseil d'Administration ne
pourront en aucun cas être remplacés par un autre représentant de leur Fédération Nationale
Art. 6.5. Tout membre du Conseil d'Administration absent à trois réunions consécutives, est automatiquement con-
sidéré comme démissionnaire. Tout membre du Conseil d’Administration qui ne répondra pas à l’accomplissement de
ses tâches, sauf à justifier de circonstances exceptionnelles, sera considéré comme démissionnaire.
Art. 6.6.
Le Président est élu directement par l’Assemblée Générale parmi les candidats se présentant pour un mandat au
Conseil d'Administration, pour autant que ces candidats aient été formellement présentés pour la présidence par leur
Fédération Nationale respective.
Une fois élu, le Président devient Membre à part entière du Conseil d'Administration L'élection du Président est suivie
de l’élection, également par l’Assemblée Générale, des autres Membres du Conseil d'Administration
Art. 6.7. Le Conseil d'Administration élit en son sein les Vice-présidents, l’un d'entre eux recevant le titre de Premier
Vice-Président
L'un des Vice-présidents devra obligatoirement assumer la charge de Trésorier, tandis qu’un des autres Vice-présidents
sera en charge des Affaires Administratives.
Art. 6.8. Le Conseil d'Administration est chargé de l’administration et de la gestion de la CEV et il détient à cet effet
les pouvoirs les plus étendus, sous réserve des compétences réservées à l’Assemblée Générale.
Art. 6.9. Le Conseil d'Administration se réunit au moins deux fois par an.
Art. 7. Comité exécutif.
Art. 7.1. Le Comité Exécutif est composé du Président et des Vice-Présidents.
Art. 7.2. Les membres du Comité Exécutif sont chargés soit individuellement, en raison de leur fonction, soit collé-
gialement, de l’exécution des décisions de l’Assemblée Générale et du Conseil d'Administration.
182528
L
U X E M B O U R G
Entre les réunions du Conseil d'Administration, le Comité Exécutif peut prendre toutes mesures urgentes, lesquelles
doivent être portées à la connaissance du Conseil d'Administration dans le mois et ratifiées par lui lors de sa plus proche
réunion
Art. 8. Le président. Le Président représente la CEV en toutes occasions
Il préside les séances de l’Assemblée Générale, du Conseil d'Administration et du Comité Exécutif. Sauf en Assemblée
Générale, sa voix est prépondérante en cas d'égalité de voix
Lorsque le Président est dans l’impossibilité temporaire d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le Premier Vice-
Président
Si cette impossibilité est définitive, il est remplacé lors de la prochaine session de l’Assemblée Générale, l’intérim étant
assuré comme en cas de remplacement temporaire.
Le Président ou son remplaçant a droit au remboursement de ses frais réels de voyage, de séjour et de représentation
lors des déplacements qu'il effectue dans le cadre de ses fonctions.
Les Vice-présidents assistent le Président
Art. 9. Chambre de médiation.
Art. 9.1. La Chambre de Médiation a la tâche de résoudre, entre des fédérations nationales affiliées et leurs membres,
toutes disputes ou conflits découlant des compétitions officielles de la CEV et conflits liés aux transferts internationaux.
Art. 9.2. Les membres de la Chambre de Médiation européenne sont confirmés par l’Assemblée Générale sur pro-
position du Conseil d’Administration
Art. 9.3. L’Assemblée Générale entérine les Règlements de la Chambre de Médiation
Art. 10. Les fédérations nationales.
Art. 10.1. Les fédérations nationales affiliées représentent la CEV dans leur pays respectif
Art. 10.2. Elles jouissent d'une large autonomie de gestion, sans pouvoir déroger à la Constitution, aux statuts, au
Code de Conduite, aux règlements et décisions de la FIVB et de la CEV.
Art. 11. Commissions & Groupes de travail.
Art. 11.1. Le Conseil d’Administration a la compétence de créer des Commissions et/ou des Groupes de Travail. La
compétence de ces Commissions et Groupes de Travail est décidée par le Conseil d’Administration et stipulée dans le
Règlement Général
Art. 11.2. En règle générale, les Commissions et les Groupes de Travail ne devront pas compter plus de neuf membres,
Président compris.
Art. 11.3. Les Présidents de Commission sont nommés par le Conseil d’Administration et ratifiés par l’Assemblée
Générale.
Art. 11.4. Les Secrétaires et les Membres des Commissions sont nommés par le Conseil d'Administration.
Le Président de la CEV a le droit d’inviter des experts à se joindre aux commissions sans être spécifiquement recom-
mandés par une fédération nationale. Dans ce cas, tous les frais y relatifs seront pris en charge par la CEV.
Art. 11.5. La présentation d'un candidat par une fédération nationale implique l’engagement, par cette dernière, de
supporter les frais de transport relatifs aux réunions auxquelles le candidat devra assister après son élection ou sa no-
mination.
Art. 11.6. Lorsqu'un membre d'une Commission se trouve dans l’impossibilité définitive d'exercer ses fonctions, il sera
pourvu à son remplacement pour la durée restante du mandat selon les dispositions de l’article 11.4.
Art. 11.7. Le remplacement d'un Président de Commission s'opèrera conformément aux dispositions de l’article 11.3
Art. 11.8. Tout membre absent à deux séances consécutives de sa Commission ou qui ne répondra pas à l’accomplis-
sement de ses tâches en vertu de l’article 3.2 du Règlement Général, sauf à justifier de circonstances exceptionnelles,
sera remplacé selon les modalités de l’article 11.4.
Art. 11.9. Les Commissions se réunissent au moins une fois par an Les Commissions sont convoquées par leur Président
ou Secrétaire.
Art. 11.10. Le Président dirige les séances, représente la Commission, veille à la bonne marche du travail et assume la
correspondance.
En cas d'égalité de voix au cours d'un vote, sa voix sera prépondérante
En cas d'empêchement temporaire, il/elle sera remplacé(e) par le Secrétaire de sa Commission, lequel ne pourra
toutefois agir qu'à titre strictement consultatif.
182529
L
U X E M B O U R G
Art. 11.11. Le Président et le Secrétaire rédigent les procès-verbaux et les rapports destinés au Conseil d'Adminis-
tration et à l’Assemblée Générale.
Art. 11.12. Les compétences particulières de chacune des Commissions, de même que les procédures relatives à leurs
activités (réunions, questions financières, etc.) sont consignées dans le Règlement Général de la CEV.
Art. 12. Le secrétariat. Le Secrétariat apportera tout le soutien administratif nécessaire et la plus large assistance aux
fédérations affiliées, ainsi qu’aux diverses institutions dont la CEV se compose
Art. 13. Finances finance.
Art. 13.1. L'exercice comptable débute le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de la même année.
Art. 13.2. Les ressources de la CEV sont constituées par:
a) les redevances et cotisations des fédérations nationales votées par l’Assemblée Générale,
b) les recettes de ses organisations,
c) les prélèvements réglementaires à l’occasion des rencontres sportives,
d) le produit des amendes qu'elle inflige,
e) les aides de toute nature admises par le Conseil d'Administration ou par l’Assemblée Générale quant à leur principe.
Art. 13.3. Le Conseil d'Administration prépare les comptes annuels et le bilan du dernier exercice comptable et
présente ces documents à l’approbation de l’Assemblée Générale.
Art. 13.4. L'Assemblée Générale approuve le budget pour l’exercice à venir, sur proposition du Conseil d'Adminis-
tration.
Art. 13.5. Deux vérificateurs aux comptes et un vérificateur suppléant sont élus par l’Assemblée Générale pour deux
ans. Ils font rapport au Conseil d'Administration et à l’Assemblée Générale de la vérification:
a) de l’exactitude des comptes et du bilan,
b) de l’existence des pièces justificatives des dépenses et des recettes,
c) du respect du budget.
Pour l’accomplissement de leur mission, ils ont accès à tous les documents comptables
Art. 13.6. La cotisation annuelle des fédérations nationales doit être payée avant le 30 juin de l’exercice en cours.
Art. 13.7. L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration, fixera les montants des redevances
relatives aux compétitions internationales auxquelles ne participent que des fédérations nationales affiliées à la CEV.
Les redevances fixes ne sont en aucune manière assimilées aux cotisations annuelles et constituent exclusivement un
droit d'inscription aux compétitions. Elles s'appliquent uniquement à la participation - non obligatoire - aux compétitions
internationales.
Art. 13.8. Le montant maximum à titre de cotisation annuelle ou de redevances fixes telles que visées aux articles 13.6
et 13.7 s'élève à 1.500.- Euros.
Art. 14. Compétitions.
Art. 14.1. Les rencontres sportives confédérales, nationales, régionales ou entre clubs sont réglementées et autorisées
dans le cadre des Statuts et règlements de la FIVB, de la CEV et des fédérations nationales, selon le cas.
Les compétitions impliquant des équipes extérieures à la juridiction de la FIVB sont soumises à l’autorisation du Comité
Exécutif de la FIVB lorsqu'il s'agit de rencontres internationales, ou de la fédération nationale concernée lorsqu'il s'agit
de compétitions à l’échelle nationale.
Art. 14.2. Toutes les rencontres dont question à l’article 14.1 se déroulent selon les lois du jeu, règlements et règles
d'arbitrage de la FIVB et de la CEV.
Art. 14.3. La CEV organise toutes les compétitions officielles suivant les critères déterminés par les règlements tech-
niques et administratifs adoptés par le Conseil d'Administration.
Elle charge une ou plusieurs fédérations nationales de l’organisation pour autant que cette ou ces fédérations aient fait
acte de candidature et garantissent la libre participation de tous les joueurs et officiels prévus tant dans la constitution
et/ou les statuts que les règlements de la FIVB et de la CEV.
Art. 14.4. Les compétitions officielles de la CEV sont organisées pour joueurs masculins et féminins et s’étendent à
toutes les compétitions de Volley-ball et de Beach Volley-ball européennes, respectivement organisées pour chacune des
catégories d’age et/ou chaque format de compétition.
Art. 15. Sanctions sanctions.
Art. 15.1. Les sanctions suivantes pourront être prononcées à l’égard des Fédérations Nationales comme suit:
a) l’avertissement simple,
182530
L
U X E M B O U R G
b) l’avertissement public,
c) les sanctions pécuniaires
d) la suspension,
e) l’expulsion.
Les sanctions [a], [b], [c] seront prononcées par le Conseil d'Administration.
Les sanctions [d], [e], seront prononcées par l’Assemblée Générale.
Toute sanction sera notifiée par lettre recommandée à la fédération ou aux fédérations concernée(s), de même qu'à
toute autre partie intéressée, le cas échéant.
Art. 15.2. Des sanctions disciplinaires et administratives prévues par les différents règlements de la CEV peuvent être
appliquées pour tous les membres des fédérations nationales mentionnés sous l’article 1.3, comme suit:
a. Réprimande simple,
b. Réprimande sévère,
c. Avertissement,
d. Sanction pécuniaire,
e. Disqualifications des compétitions,
f. Défaite de match ou inversement de résultat,
g. Modifications des résultats sportifs,
h. Démission de position officielle,
i. Suspension,
j. Expulsion.
La compétence pour imposer des sanctions est décrite dans les Statuts et le Code de Discipline
Toute sanction sera notifiée par lettre recommandée à la fédération nationale affiliée concernée et à toute autre partie
directement engagée.
Art. 15.3. Les sanctions sont rendues publiques de la manière fixée par le Conseil d'Administration sauf avertissement
simple.
Art. 15.4. Le Comité Exécutif peut appliquer l’avertissement simple aux fédérations nationales n'ayant pas payé leur
cotisation à l’échéance.
Art. 15.5. En règle générale, la suspension est infligée par l’Assemblée Générale. Le Conseil d'Administration peut
également infliger la suspension, en justifiant l’urgence.
La suspension par l’Assemblée Générale prend effet immédiatement, celle par le Conseil d'Administration à partir de
la notification.
L'instance qui prononce la suspension en fixe la durée et peut fixer une autre date de départ que celle prévue à l’alinéa
précédent.
Art. 15.6. Avant d'appliquer une sanction, l’organe qui se propose de l’infliger doit donner l’occasion à la fédération
visée de faire valoir ses moyens de défense, oralement ou par écrit.
Art. 15.7. Toute sanction peut être annulée par l’instance qui l’a appliquée en respectant les formes et les majorités
prévues pour l’application de la sanction.
Art. 15.8. Les sanctions infligées par la CEV sont exécutoires dans l’ensemble des fédérations affiliées à la CEV. Le
Conseil d'Administration peut demander à la FIVB d'étendre les sanctions à l’ensemble de la FIVB.
Art. 15.9. La CEV reconnaît et applique, pour ce qui la concerne, les sanctions prises par la FIVB et par les fédérations
nationales, dès le jour où il lui en aura été donné notification.
Art. 16. Dissolution. En cas de dissolution de la CEV, l’Assemblée Générale de la CEV décidera de l’affectation des
fonds et des biens de la CEV
Art. 17. Dispositions diverses. Les présentes modifications aux Statuts ont été ratifiées par l’Assemblée Générale réunie
à ANTALYA (Turquie) en date du 25 octobre 2014.
Leur entrée en vigueur est régie par l’application de l’article 5.18.
Art. 18. Omissions. Toutes matières non explicitement prévues dans les Statuts de la CEV seront régies par le Règle-
ment Organique ou, à défaut, par la loi luxembourgeoise du 21 avril 1928, complétée et modifiée par la loi luxembour-
geoise du 4 mars 1994 portant réglementation des a.s.b.l. et institutions d'utilité publique.
182531
L
U X E M B O U R G
STATUTES
Art. 1. General, Authority, Seat, Languages.
Art. 1.1. The European Volleyball Confederation (CEV) a.s.b.l. shall be the association of the national federations,
affiliated to the FIVB, in the geographical area referred to in Article 1.2.
Art. 1.2. The CEV shall be the sole representative of the FIVB in the geographical area assigned to it by the FIVB.
The CEV shall be represented at the FIVB Board of Administration according to the terms exposed in Art. 5.9 hereafter
and Chapter 6 of the General Regulations of the CEV.
Art. 1.3. The national federations shall abide by the Constitution and/or Statutes, regulations, rules of the game and
decisions of the FIVB and the CEV. This obligation shall also extend to all members of those National Federations including
clubs, officials, assisting personnel, referees, players, coaches, team members and all persons acting within their respon-
sibility, by means of their statutes and regulations.
Art. 1.4. The seat of the CEV shall be established at Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
Art. 1.5. The official languages shall be:
- English;
- French;
The Official working language is English. All official notices and all correspondence must be in English. In case of any
conflict or dispute regarding the interpretation of texts drafted in the two languages, the English version shall prevail.
Statutes and any legal documents shall be drafted in English and French in accordance with the Luxembourgish laws
governing non-profit organizations.
Art. 1.6. The association shall be formed for an indeterminate period and shall be recognized by the FIVB.
Art. 2. Aims & Tasks. The CEV shall pursue, in the geographical area assigned to it, the aims of the FIVB to encourage
the development and growth of the sport of volleyball in all its forms as set out in Article 1.4 of the FIVB Constitution,
with particular emphasis on:
Art. 2.1. Coordinating the activity of the national federations, to promote the mutual cooperation and understanding
between them and settling any disputes.
Art. 2.2. Fostering the development of friendly relations between the national federations and the officials, trainers,
referees and players.
Art. 2.3. Ensuring adherence to the FIVB Constitution, Code of Conduct, Regulations, Official Rules and decisions of
FIVB.
Art. 2.4. Promoting the expansion and popularity of volleyball in all its forms.
Art. 2.5. Encouraging the formation of national federations and their membership in the FIVB.
Art. 2.6. Organising the Continental Championships and all other official competitions.
Art. 2.7. Establishing the timetable of international events and informing the FIVB Sports Event Council of such time-
table.
Art. 2.8. Arousing the public authorities’ interest in volleyball.
Art. 2.9. Encouraging the organization of courses and advanced training sessions in both technical subjects and refer-
eeing.
Art. 2.10. Ensuring the improvement of sports materials and equipment
Art. 3. Membership.
Art. 3.1. The minimum number of affiliated national federations shall be three.
Art. 3.2. A National Federation may become a CEV member after having completed the process of affiliation to the
FIVB and following the decision of the CEV General Assembly.
All applications shall be made to the Board of Administration in writing.
Such written application shall imply the unconditional acceptance of the Statutes and General Regulations and decisions
of CEV.
Art. 3.3. Any federation may, at any time, leave the association, provided it has met all its financial obligations.
Any resignation shall be notified by registered letter to the Board of Administration.
The General Assembly alone shall be empowered to exclude a member of the association, provided, however, that
two thirds of the votes have been cast in favour of such decision and that the full member in question has been heard
beforehand.
182532
L
U X E M B O U R G
Art. 4. Institutions.
Art. 4.1. The institutions of the CEV:
4.1.1 The General Assembly.
4.1.2 The Board of Administration.
4.1.3 The Executive Committee.
4.1.4 The Commissions.
4.1.5 The Auditors.
Art. 4.2. The Mediation Chamber.
Art. 4.3. The Working Groups.
Art. 4.4. The Secretariat.
Art. 4.5. Age limit of CEV Officials
According to Art. 2.1.4 of the Constitution of the FIVB, an age limit of 75 years shall apply to all CEV officials, elected
or nominated to any position of responsibility in CEV. Such age limit shall become effective on 31 December of the civil
year during which they reach the age limit or at the latest at the end of their term of office.
Art. 5. General assembly.
Art. 5.1. The General Assembly of the affiliated national federations in accordance with Art. 3.2 of these statutes shall
constitute the supreme authority of the CEV. Its decisions shall be binding on and enforceable in respect of the institutions
of both the CEV and the national federations.
Art. 5.2. The General Assembly shall comprise delegates accredited for this purpose by the member federations. Only
the delegates of federations which have fulfilled their obligations and financial commitments to the CEV shall participate
in General Assemblies.
Delegates who are not allowed to participate in General Assemblies may attend them without the right to speak or
vote.
The General Assembly shall be open when at least two thirds of the federations with the right to participate are present
or represented.
Art. 5.3. Each member federation may accredit a maximum of two delegates.
The accredited delegates must be members of the federation concerned or have the nationality of the country in
question. Current members of the Board of Administration may not be accredited as delegates of their federation.
The names of the delegates shall appear on an accreditation document giving them powers of deliberation and listing
them in order of precedence. This document shall be signed by the President and the Secretary-General of the federation
concerned and bear that federation’s official seal. It must be lodged with the Secretariat of the General Assembly before
the meeting opens.
Art. 5.4. Any member federation may be represented by the accredited delegates of another member federation.
Delegates accredited by one member federation may not represent more than one further member federation. The
power of representation shall appear on a document designating the member federation whose accredited delegates are
to be the agents. This document shall be signed by the President and the Secretary-General of the federation concerned
and bear that federation’s official seal. It must be lodged with the Secretariat of the General Assembly before the meeting
opens.
Art. 5.5. Delegates shall have one vote for each federation represented in accordance with Article 5.4.
Art. 5.6. The validity of the documents referred to in Article 5.3 and Article 5.4 shall be checked by a Credentials
Committee appointed by the General Assembly. Voting shall not take place until the said committee has made its report.
Art. 5.7. The Credentials Committee shall consist of four members.
Art. 5.8. The General Assembly shall hold an ordinary meeting every year. The General Assembly alone shall be
empowered to derogate from this rule in respect of the following year.
Conditions for the organization of the General Assembly are defined in the CEV General Regulations.
Art. 5.9. The date and place of the General Assembly shall be notified to the national federations at least six months
in advance.
According to Art. 2.4.1.2 of the Constitution of FIVB, during the year preceding the Summer Olympic Games, CEV
shall hold its General Assembly of the corresponding year in order to elect its members to the FIVB Board of Adminis-
tration, including the President of the CEV, as fixed in Chapter VI of the General Regulations.
Art. 5.10. The two official languages of the CEV shall be the only languages used at meetings of the General Assembly.
Where necessary, the national federations shall provide their own interpreters.
182533
L
U X E M B O U R G
Official documents presented during the General Assembly shall only be distributed in English; they shall benefit from
simultaneous translation in French whenever appropriate.
Art. 5.11. Any proposals which a national federation wishes to put to the General Assembly shall be sent, in writing,
to the Secretariat at least four months before the date of the opening of the General Assembly.
Proposed amendments to the Statutes shall be examined by the Legal Commission, which shall report to the Board
of Administration and the General Assembly. That Commission shall be empowered to suggest a different wording,
although the substance of the text must remain faithful to the original draft.
Art. 5.12. Applications for vacant posts in the organs of the CEV shall be made in writing by the national federations
and sent by registered letter with acknowledgment of receipt to the Secretariat no later than three months before the
date of the opening of the General Assembly.
The time limit referred to in the previous paragraph shall not apply in the case provided for in Article 6.3.
Each national federation may only put up one candidate per CEV bodies.
The putting up of a candidate shall imply a commitment on the part of the federation concerned to cover the transport,
board and lodging costs in respect of the meetings to be attended by the candidate once elected or appointed.
Art. 5.13. The agenda shall be circulated to the national federations no later than three months before the date of the
opening of the General Assembly.
Only items appearing on the agenda shall be discussed.
In an emergency, items which are not on the agenda may be discussed provided the General Assembly decides to do
so by a two thirds majority of the votes cast.
The items listed below must appear on the agenda of an ordinary General Assembly:
a) President’s opening speech;
b) Installation of the officers;
c) Report of the credentials committee;
d) Approval of the minutes of the previous General Assembly;
e) Presentation and adoption of the CEV reports of activity;
f) Presentation of the financial report;
g) Auditors’ reports;
h) Discussion and approval of the accounts;
i) Discussion and approval of the programs of activity and the budget;
j) Presentation of commissions reports;
k) Voting on proposals submitted pursuant to Article 5.11;
l) Statutory elections
m) Any Other Business;
n) President’s closing speech.
Art. 5.14. The General Assembly shall hold an extraordinary meeting at the decision of the Board of Administration
or at the request of at least one third of the national federations. In such a case, the federations shall be informed of the
date, place and agenda of the meeting at least three months in advance.
Art. 5.15. Voting shall be by a show of hands and decisions shall be taken by a simple majority of the votes cast, other
than in the exceptional cases provided for in the present Statutes.
Voting shall be by roll call on the decision of the President where a show of hands is not clear enough, or at the request
of five national federations. Voting shall be in alphabetical order of the countries represented.
The decisions shall be adopted by an absolute majority, i.e. when they poll more than half of the votes cast.
Any voting on individual persons shall be by secret ballot. On the first round, candidates obtaining an absolute majority
shall be elected and, on the second round, those who obtain the most votes shall be elected. In the event of equal votes,
a further vote shall be cast.
The Statutes shall be amended by a majority of at least two thirds of the votes.
Two thirds of the full members must be present or represented.
Art. 5.16. The minutes of the General Assembly shall be drafted by the Secretariat of the CEV in two official languages
of the CEV. In the case of any dispute over the interpretation of these minutes, the English version shall prevail.
The minutes of the General Assembly shall be sent to the national federations within three months of the closing of
the General Assembly: they may be consulted at the seat of the Confederation and shall be published in the official organ
of the CEV.
They shall be approved provisionally by the Board of Administration and definitively by the next General Assembly.
182534
L
U X E M B O U R G
Art. 5.17. The General Assembly may, at the proposal of the Board of Administration, award the titles of Honorary
President, Honorary Vice-President or Honorary member to persons having held the respective posts and to anyone
who has been of outstanding service to the CEV.
Art. 5.18. Unless the General Assembly decides otherwise, its decisions should become effective immediately.
All decisions shall also be notified in writing to the national federations, within 30 days of the closing of the General
Assembly.
Art. 6. Board of administration.
Art. 6.1. The Board of Administration shall comprise of 17 members (including the President) elected by the General
Assembly.
Among the elected members must be at least two persons of each gender. If only candidates of the same gender are
elected among the 17, then only the first 15 (including the President) are declared elected and the others will be the 2
from the minority gender who have achieved the most votes. If only one candidate of the minority gender is elected
among the 17, then only the first 16 (including the President) are declared elected and the other will be the one from
the minority gender who has achieved the most votes. In case there are not enough candidates, the Board of Adminis-
tration will be completed by supplementary election during the next General Assembly.
The function of President of the Financial Commission shall be assumed by the Vice-President taking on the duties of
Treasurer as foreseen by the dispositions of article 6.7.
Art. 6.2. Applications for membership of the Board of Administration must be submitted as provided for in Article
5.12.
Art. 6.3. The term of office of the Board of Administration shall be four years, until the General Assembly of the fourth
year after the year of the election. Any member unable to complete that term of office shall not be replaced until the
next General Assembly.
In this event, all the national federations shall be informed immediately of such resignation and shall receive the ap-
propriate directives on fall-back arrangements until the next General Assembly.
Any resignation not notified to the CEV at least two months prior to the General Assembly shall not be the subject
of fall-back arrangements before the next meeting of the General Assembly.
Any supplementary election of a member of the Board of Administration shall be for the remaining term of office.
Art. 6.4. In the event of temporary or unforeseeable absence, a member of the Board of Administration may in no
case be replaced by another representative of his national federation.
Art. 6.5. Any member of the Board of Administration missing three consecutive meetings shall automatically be deemed
to have resigned. Any member of the Board of Administration who fails to fulfill his duties and is unable to plead exceptional
circumstances shall be considered to have resigned.
Art. 6.6. The President shall be elected directly by the General Assembly from the candidates standing for the Board
of Administration, provided such candidates have been formally nominated for the presidency by their respective national
federations.
Once elected, the President shall become a full member of the Board of Administration.
The election of the President shall be followed by the election, also by the General Assembly, of the other members
of the Board of Administration.
Art. 6.7. The Board of Administration shall elect from amongst its member the Vice-Presidents, one of whom shall be
designated Senior Vice-President.
One of the Vice-Presidents must take on the duties of Treasurer, whilst another Vice-President will be in charge of
Administrative Affairs.
Art. 6.8. The Board of Administration shall be responsible for the administration and management of the CEV and
shall, for this purpose, have the broadest powers, subject to the powers of the General Assembly.
Art. 6.9. The Board of Administration shall meet at least twice a year.
Art. 7. Executive committee.
Art. 7.1. The Executive Committee shall consist of the President and the Vice-Presidents.
Art. 7.2. The members of the Executive Committee shall be responsible jointly or, by virtue of their posts, severally
for implementation of the decisions of the Board of Administration and the General Assembly.
Between meetings of the Board of Administration, the Executive Committee may take all urgent measures, which must
be notified within a month to the Board of Administration, which shall ratify them at its next meeting.
Art. 8. The president. The President shall represent the CEV on all occasions.
182535
L
U X E M B O U R G
He shall chair the meetings of the General Assembly, the Board of Administration and the Executive Committee. Other
than in the General Assembly, he shall have the casting vote.
In the event of the President being temporarily unable to perform his duties, he shall be replaced by the Senior Vice-
President.
In the event of such inability being permanent, he shall be replaced at the next meeting of the General Assembly, the
interim period being covered as in the case of temporary replacement
The President or his replacement shall be entitled to reimbursement of the travel, board, lodging and representation
costs actually incurred on missions carried out as part of his duties.
The Vice-Presidents shall assist the President.
Art. 9. Mediation chamber.
Art. 9.1. The Mediation Chamber has the duty to resolve any disputes or conflicts between affiliated national federations
and their members arising from the CEV competitions and items related to the International Transfers.
Art. 9.2. The members of the European Mediation Chamber shall be confirmed by the General Assembly upon proposal
of the Board of Administration.
Art. 9.3. The General Assembly shall approve the Regulations of the Mediation Chamber.
Art. 10. The national federations.
Art. 10.1. The affiliated national federations shall represent the CEV in their respective countries.
Art. 10.2. They shall have considerable autonomy of management, but must comply with the Constitution, Statutes,
Code of Conduct, regulations and decisions of the FIVB and the CEV.
Art. 11. Commissions & Working groups.
Art. 11.1. The Board of Administration has the competence to create Commissions and/or Working Groups. The
competence of these Commissions and Working Groups is decided by the Board of Administration and fixed in the
General Regulations.
Art. 11.2. As a general rule, Commissions and Working Groups shall consist of no more than nine members, Chairman/
Chairwoman included.
Art. 11.3. The Presidents of the Commissions shall be appointed by the Board of Administration and ratified by the
General Assembly.
Art. 11.4. Commission Secretaries and Members shall be appointed by the Board of Administration.
The CEV President is entitled to invite experts not proposed by a national federation to any commission. In such case,
any related cost will be covered by CEV.
Art. 11.5. The putting up of a candidate by a national federation shall imply that such federation undertakes to cover
the cost of transport, in respect of the meetings to be attended by the candidate once elected or appointed.
Art. 11.6. In the event of a Commission member being permanently unable to perform his/her duties, he shall be
replaced for the rest of his/her term of office as provided for in Article 11.4.
Art. 11.7. Commission Presidents shall be replaced as provided for in Article 11.3.
Art. 11.8. Any member who misses two consecutive meetings of his Commission or does not fulfill his duties according
to the article 3.2 of the General Regulations and is unable to plead exceptional circumstances shall be replaced as provided
for in Article 11.4.
Art. 11.9. Commissions shall meet at least once a year.
Commissions shall be convened by their President or Secretary.
Art. 11.10. The President shall run meetings, represent the Commission, ensure that the work is carried out properly
and be responsible for any correspondence.
He/she shall have the casting vote.
In the event of the President being temporarily unable to perform his/her duties, he/she shall be replaced by the
Secretary of the Commission, who may, however, only act in a strictly advisory capacity.
Art. 11.11. The President and Secretary shall draft the minutes and the reports for the Board of Administration and
the General Assembly.
Art. 11.12. The specific responsibilities of each of the Commissions and the procedures related to their activity (meet-
ings, financial matters etc.) shall be laid down in the General Regulations of the CEV.
182536
L
U X E M B O U R G
Art. 12. The secretariat. The Secretariat shall provide administrative support and broader assistance for the member
federations and for the various bodies and institutions of the CEV
Art. 13. Finance.
Art. 13.1. The accounting year shall start on 1
st
January and end on 31
st
December of the same year.
Art. 13.2.
The resources of the CEV shall be:
a) the national federations’ dues and contributions, as passed by the General Assembly,
b) the revenue of its organizations,
c) the regulation levies accruing from sporting events,
d) the product of any fines,
e) aid of all kinds, the principle of which has been approved by the Board of Administration or the General Assembly.
Art. 13.3. The Board of Administration shall prepare the annual accounts and the balance of the last accounting year
and shall present such documents for the approval of the General Assembly.
Art. 13.4. The General Assembly shall approve the budget for the forthcoming accounting year, on a proposal from
the Board of Administration.
Art. 13.5.
Two auditors and one alternate shall be elected by the General Assembly for a period of two years. They shall report
to the Board of Administration and the General Assembly on:
a) the faithfulness of the accounts and the balance sheet,
b) the existence of documents in support of the expenditure and revenue,
c) adherence to the budget.
In the performance of their duties, they shall have access to all the accounting documents
Art. 13.6. The national federations’ annual contribution shall be paid by 30 June of the current accounting year.
Art. 13.7. The General Assembly, on a proposal from the Board of Administration, shall fix the amount of the dues in
respect of the international competitions in which only national federations which are members of the CEV are involved.
Such dues shall in no way be assimilated to the annual contribution and shall constitute nothing more than the fees for
taking part in the competitions. They shall apply solely to - optional - involvement in international competitions.
Art. 13.8. The annual contribution or dues referred to in Article and Article 13.7 shall not exceed 1.500. - Euros
Art. 14. Competitions.
Art. 14.1. Confederation, national, regional and club events shall be regulated and authorised, as appropriate, under
the Statutes and regulations of the FIVB, the CEV or the national federations.
Competitions involving teams outside the jurisdiction of the FIVB shall come under the authority of the Executive
Committee of the FIVB in the case of international meetings and under the authority of the national federation concerned
in the case of national competitions.
Art. 14.2. All meetings referred to in Article 14.1 shall take place in accordance with the rules of the game, the
regulations and refereeing guidelines of the FIVB and the CEV.
Art. 14.3. The CEV shall organize all official competitions in the light of the criteria laid down in the technical and
administrative regulations adopted by the Board of Administration.
It shall invite one or more national federation(s) to organize such competitions provided that such federation(s) have
applied for this and guarantee the free participation of all the players and officials provided for in the Constitution and/
or Statutes and regulations of the FIVB and the CEV.
Art. 14.4. The official competitions of the CEV shall be run for both sexes and be extended to all Volleyball and Beach
Volleyball European competitions, respectively for each age category and/or competition format.
Art. 15. Sanctions.
Art. 15.1. Sanctions for National Federations may be applied as follows:
a) an ordinary warning,
b) a public warning,
c) a financial sanction
d) suspension,
e) expulsion.
182537
L
U X E M B O U R G
Sanctions [a], [b] and [c] shall be pronounced by the Board of Administration.
Sanctions [d] and [e] shall be pronounced by the General Assembly.
All sanctions shall be notified by registered letter, to the federation(s) concerned and to any other interested party.
Art. 15.2. Disciplinary and administrative sanctions provided for in the various CEV Regulations may be applied to all
members of the National Federations mentioned in Article 1.3 as follows:
a. Simple admonition,
b. Severe admonition,
c. Warning,
d. Financial sanction
e. Disqualification from competitions,
f. Loss of matches or reversal of results,
g. Modification on competition results,
h. Discharge from official position,
i. Suspension,
j. Expulsion.
The competence to impose sanctions is described in the Statutes and the Code of Discipline
All sanctions shall be notified by registered letter, to the affiliated national federation(s) concerned and to any other
party directly involved.
Art. 15.3. Sanctions other than ordinary warnings shall be made public as provided for by the Board of Administration.
Art. 15.4. The Executive Committee may issue an ordinary warning to national federations which have not paid their
contributions in time.
Art. 15.5. As a general rule, suspension shall be pronounced by the General Assembly. The Board of Administration
may also pronounce suspension in urgent cases.
Suspension by the General Assembly shall take effect immediately. Suspension by the Board of Administration shall
take effect as from notification.
The body pronouncing suspension shall lay down the duration and may make it take effect at a time different from
that laid down in the previous paragraph.
Art. 15.6. Before application of a sanction, the body intending to pronounce it must give the federation concerned the
opportunity to defend itself, orally or in writing.
Art. 15.7. Any sanction may be set aside by the body which applied it in accordance with the forms and majorities laid
down for application of such sanction.
Art. 15.8. Sanctions applied by the CEV shall be enforceable in all affiliated federations of the CEV. The Board of
Administration may apply to the FIVB to extend the sanctions to the whole of the FIVB.
Art. 15.9. The CEV shall recognize and apply, for its part, any sanctions pronounced by the FIVB and the national
federations as soon as it is notified thereof.
Art. 16. Dissolution. In the event of dissolution of the CEV, the General Assembly of the CEV shall decide on the
allocation of the CEV’s monies and goods.
Art. 17. Various provisions. These amended Statutes were ratified by the General Assembly in ANTALYA (Turkey)
on 25
th
October 2014.
They shall take effect as laid down in Article 5.18.
Art. 18. Omissions. Any subject not explicitly provided for in the CEV Statutes shall be regulated by the Internal
Regulations or, failing this, by the Luxembourg Act of 21
st
April 1928, as amended by the Luxembourg ASBL and Public
Utilities (Regulation) Act of 4
th
March 1994.
Référence de publication: 2014184079/718.
(140207971) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2014.
Thonex Villeneuve S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue de Dahlias.
R.C.S. Luxembourg B 181.942.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
182538
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014183877/9.
(140206683) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2014.
Foodco Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 191.005.
En date du 20 octobre 2014, la Société a changé son siège social du 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg au 5,
rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
Il résulte des résolutions de l'associé unique de la Société prises en date du 20 octobre 2014 que:
- L'associé unique a décidé de nommer Cédric Pedoni, né le 24 mars 1975 à Villerupt, France, ayant son adresse
professionnelle à 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, en tant que gérant de catégorie A de la Société, avec effet
immédiat et pour une durée indéterminée.
- L'associé unique a décidé de nommer Telmo Ribeiro Valido, né le 26 juillet 1976 à Cascais, Portugal, ayant son adresse
professionnelle à 33, Bockenheimer Landstrasse, D-60325 Frankfurt am Main, Allemagne, en tant que gérant de catégorie
A de la Société, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
- L'associé unique a décidé de nommer Ingrid Moinet, née le 5 décembre 1975 à Bastogne, Belgique, ayant son adresse
professionnelle à 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, en tant que gérante de catégorie C de la Société, avec effet
immédiat et pour une durée indéterminée.
- L'associé unique a décidé de nommer Quentin de Neve de Roden, né le 27 mai 1975 à Ixelles, Belgique, ayant son
adresse professionnelle à 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, en tant que gérant de catégorie C de la Société,
avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
Il en résulte qu'à compter du 20 octobre 2014, le conseil de gérance de la Société est composé comme suit:
- Séverine Michel, gérante de catégorie A
- Kees Jager, gérant de catégorie A
- Eddy Perrier, gérant de catégorie A
- Telmo Ribeiro Valido, gérant de catégorie A
- Cédric Pedoni, gérant de catégorie A
- Christophe Gammal, gérant de catégorie B
- Michaël Goosse, gérant de catégorie B
- Ingrid Moinet, gérante de catégorie C
- Quentin de Neve de Roden, gérant de catégorie C
Il résulte d'une convention de transfert de parts sociales prenant effet au 20 octobre 2014 que:
Telefood S.à r.l., ayant son siège social à 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg et enregistré au R.C.S. de Lu-
xembourg sous le numéro B 119 045 a transféré 72,204 parts sociales de catégorie B de la Société à Valencia Investors
Limited, ayant son siège social au Maples Corporate Services Limited PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman,
KY1-1104, Cayman Islands et enregistré au Cayman Islands Registrar of Companies sous le numéro MC-286566;
Telefood S.à r.l. Prénommée, a transféré 44,754 parts sociales de catégorie B de la Société à Presidio Investors Limited,
ayant son siège social au Maples Corporate Services Limited PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104,
Cayman Islands et enregistré au Cayman Islands Registrar of Companies sous le numéro MC-285613;
Telefood S.à r.l. Prénommée, a transféré 179,018 parts sociales de catégorie B de la Société à Spruce Investors Limited,
ayant son siège social au Maples Corporate Services Limited PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104,
Cayman Islands et enregistré au Cayman Islands Registrar of Companies sous le numéro MC-273221;
Telefood S.à r.l. Prénommée, a transféré 10,961 parts sociales de catégorie B de la Société à Oregon Public Employees
Retirement Fund, ayant son siège social au 350 Winter Street N.E., Suite 100 Salem, Oregon 97301-3896, Etats Unis
d'Amérique et enregistré sous l'Employer Identification Number 93-6001869;
Telefood S.à r.l. Prénommée, a transféré 52,148 parts sociales de catégorie B de la Société à ESCF Investment S.à r.l.,
ayant son siège social au 296-298 route de Longwy, L-1940 Luxembourg et enregistré au R.C.S. de Luxembourg sous le
numéro B 164 109;
Telefood S.à r.l. Prénommée, a transféré 8,998 parts sociales de catégorie B de la Société à SPFC Investment S.à r.l.,
ayant son siège social au 296-298 route de Longwy, L-1940 Luxembourg et enregistré au R.C.S. de Luxembourg sous le
numéro B 175 373;
Telefood S.à r.l. Prénommée, a transféré 4,370 parts sociales de catégorie B de la Société à CMSC Investment S.à r.l.,
ayant son siège social au 296-298 route de Longwy, L-1940 Luxembourg et enregistré au R.C.S. de Luxembourg sous le
numéro B 174 424;
182539
L
U X E M B O U R G
Telefood S.à r.l. Prénommée, a transféré 7,704 parts sociales de catégorie B de la Société à OHA Centre Street
Partnership, L.P., ayant son siège social au 1114 Avenue of the Americas, 27
ème
étage, New York, NY 10036, Etats Unis
d'Amérique et enregistré au Secretary of State de Delaware sous le numéro 5159187;
Telefood S.à r.l. Prénommée, a transféré 2,309 parts sociales de catégorie B de la Société à Master SIF SICAV-SIF,
ayant son siège social au 31, Z.A. Bourmich, L - 8070 Bertrange et enregistré au R.C.S. de Luxembourg sous le numéro
B 159 968;
Telefood S.à r.l. Prénommée, a transféré 9,844 parts sociales de catégorie B de la Société à CDP ESCF Investment S.à
r.l, ayant son siège social au 296-298 route de Longwy, L-1940 Luxembourg et enregistré au R.C.S. de Luxembourg sous
le numéro B 186 838;
Telefood S.à r.l. Prénommée, a transféré 8,377 parts sociales de catégorie B de la Société à Asia CCF Investment II S.à
r.l., ayant son siège social au 296-298 route de Longwy, L-1940 Luxembourg et enregistré au R.C.S. de Luxembourg sous
le numéro B 188 645;
Telefood S.à r.l. Prénommée, a transféré 49,313 parts sociales de catégorie B de la Société à FBC HOLDINGS S.à r.l.,
ayant son siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg et enregistré au R.C.S. de Luxembourg sous le
numéro B 142 133;
Telefood S.à r.l. Prénommée, a transféré 69,643 parts sociales de catégorie C de la Société à FBC HOLDINGS S.à r.l.,
ayant son siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg et enregistré au R.C.S. de Luxembourg sous le
numéro B 142 133;
Telefood S.à r.l. Prénommée, a transféré 19,831 parts sociales de catégorie C de la Société à Alcentra Mezzanine No.
1 S.à r.l., ayant son siège social au 47, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg et enregistré au R.C.S. de Luxembourg
sous le numéro B 107 703;
Telefood S.à r.l. Prénommée, a transféré 3,383 parts sociales de catégorie C de la Société à Alcentra Mezzanine QPAM
S.à r.l., ayant son siège social au 47, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg et enregistré au R.C.S. de Luxembourg sous
le numéro B 114 912;
Telefood S.à r.l. Prénommée, a transféré 23,214 parts sociales de catégorie C de la Société à ALMACK S.A., ayant son
siège social au 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg et enregistré au R.C.S. de Luxembourg sous le numéro B
111 756;
Telefood S.à r.l. Prénommée, a transféré 23,214 parts sociales de catégorie C de la Société à Friday Street Mezzanine
I S.à r.l., ayant son siège social au 55, Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg et enregistré au R.C.S. de Luxembourg sous
le numéro B 118 181;
Telefood S.à r.l. Prénommée, a transféré 10,535 parts sociales de catégorie C de la Société à HARVEST CLO II S.A.,
ayant son siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg et enregistré au R.C.S. de Luxembourg sous le
numéro B 106 360;
Telefood S.à r.l. Prénommée, a transféré 12,680 parts sociales de catégorie C de la Société à Harvest CLO III plc, ayant
son siège social au 5 Harbourmaster Place, IFSC, Dublin 1, Irlande et enregistré au Companies Registration Office Irlandais
sous le numéro 408100.
Il en résulte, qu'à compter du 20 octobre 2014, le capital de la Société est réparti comme suit:
- Telefood S.à r.l.: 637,500 parts sociales de catégorie A
- Valencia Investors Limited: 72,204 parts sociales de catégorie B
- Presidio Investors Limited: 44,754 parts sociales de catégorie B
- Spruce Investors Limited: 179,018 parts sociales de catégorie B
- Oregon Public Employees Retirement Fund: 10,961 parts sociales de catégorie B
- ESCF Investment S.à r.l.: 52,148 parts sociales de catégorie B
- SPFC Investment S.à r.l.: 8,998 parts sociales de catégorie B
- CMSC Investment S.à r.l.: 4,370 parts sociales de catégorie B
- OHA Centre Street Partnership, L.P.: 7,704 parts sociales de catégorie B
- Master SIF SICAV-SIF: 2,309 parts sociales de catégorie B
- CDP ESCF Investment S.à r.l.: 9,844 parts sociales de catégorie B
- Asia CCF Investment II S.à r.l.: 8,377 parts sociales de catégorie B
- FBC HOLDINGS S.à r.l.: 49,313 parts sociales de catégorie B
- FBC HOLDINGS S.à r.l: 69,643 parts sociales de catégorie C
- Alcentra Mezzanine No. I S.à r.l.: 19,831 parts sociales de catégorie C
- Alcentra Mezzanine QPAM S.à r.l.: 3,383 parts sociales de catégorie C
- ALMACK S.A.: 23,214 parts sociales de catégorie C
- Friday Street Mezzanine I S.à r.l.: 23,214 parts sociales de catégorie C
- HARVEST CLO II S.A.: 10,535 parts sociales de catégorie C
182540
L
U X E M B O U R G
- Harvest CLO III plc: 12,680 parts sociales de catégorie C
Eddy Perrier
<i>Gérant de catégorie Ai>
Référence de publication: 2014184167/115.
(140207479) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2014.
HayFin Jade LuxCo 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 178.570.
<i>Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire du 24 novembre 2014:i>
- Est nommé gérant de classe B de la société pour une période indéterminée Mme. Nahima Bared, employée privée,
résidant professionnellement au 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg en remplacement du gérant dé-
missionnaire Mme. Heike Kubica, avec effet au 24 novembre 2014.
Luxembourg, le 24 novembre 2014.
Signatures
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2014184939/15.
(140208650) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2014.
HayFin Jade LuxCo 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 178.571.
<i>Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire du 24 novembre 2014:i>
- Est nommé gérant de classe B de la société pour une période indéterminée Mme. Nahima Bared, employée privée,
résidant professionnellement au 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg en remplacement du gérant dé-
missionnaire Mme. Heike Kubica, avec effet au 24 novembre 2014.
Luxembourg, le 24 novembre 2014.
Signatures
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2014184940/15.
(140208649) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2014.
Immobiliengesellschaft Edward Steichen Building Kirchberg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2215 Luxembourg, 4, rue de Neuerburg.
R.C.S. Luxembourg B 89.167.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014184974/9.
(140208397) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2014.
Superbricolux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4832 Rodange, 402, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 66.798.
Le Bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014185217/9.
(140208342) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2014.
182541
L
U X E M B O U R G
Supercell S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l'Aveugle.
R.C.S. Luxembourg B 143.373.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014185218/9.
(140208632) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2014.
Syan Corporate, Société Anonyme.
Siège social: L-8011 Strassen, 283, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 136.061.
Les comptes annuels au 31/12/13 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014185221/9.
(140208594) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2014.
TalkingBird S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7716 Colmar-Berg, 34, rue Belle Vue.
R.C.S. Luxembourg B 168.944.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014185224/9.
(140208701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2014.
JP Commercial IX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 6, rue Dicks.
R.C.S. Luxembourg B 156.960.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014184995/9.
(140208599) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2014.
Comptoir Technique et Industriel S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8011 Strassen, 321, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 6.229.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014184778/9.
(140208363) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2014.
CS Energies SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 4-6, avenue Victor Hugo.
R.C.S. Luxembourg B 143.228.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014184791/9.
(140208831) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2014.
182542
L
U X E M B O U R G
Boetie Propco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R.C.S. Luxembourg B 189.943.
In the year two thousand and fourteen, on the eleventh of November
Before Us Me Jean SECKLER, notary residing at Junglinster, (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned;
APPEARED:
Boetie Luxco S.à r.l., a private limited liability company (“société à responsabilité limitée”) incorporated under the laws
of Luxembourg, having its registered office at L-2212 Luxembourg, 6, Place de Nancy, Grand Duchy of Luxembourg,
registered with the Luxembourg trade and companies' register (R.C.S. Luxembourg) under number B 189.940 here
represented by Mr. Henri DA CRUZ, employee, residing professionally in Junglinster, by virtue of a proxy given under
private seal; such proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy-holder and the notary, will remain attached
to the present deed in order to be recorded with it.
This appearing party, through its mandatory, has declared and requested the officiating notary to act the following:
- That the private limited liability company (“société à responsabilité limitée») “Boetie Propco S.à r.l.”, (the "Company"),
with registered office in L-2370 Howald, 1, rue Peternelchen, registered at the Companies and Trade Register of Lu-
xembourg (“Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg), section B, number 189.943, incorporated by deed
of Maître Jean-Paul MEYERS, civil law notary residing in Rambrouch, Grand Duchy of Luxembourg, on the 27
th
of August
2014, published in the Mémorial C number 2457 of the 12
th
of September 2014. The articles of incorporation have been
amended by a deed drawn up by Maître Jean-Paul MEYERS, civil law notary residing in Rambrouch, Grand Duchy of
Luxembourg, on the 29
th
of September 2014, in process of being published in the Mémorial C.
- That the appearing party, represented as said before, is the sole actual partner of the said company and that it has
taken, through its mandatory, the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting decides to transfer the registered office of the Company from Luxembourg to L-2212 Luxem-
bourg, 6, Place de Nancy, and subsequently to amend article 4 of the bylaws as follows:
" Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the municipality the registered office may be transferred by means of a decision of the board of managers.
It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general
meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution
of the board of managers.
4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances
or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
traordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwiths-
tanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.."
<i>Second resolutioni>
The general meeting aknowledges that the Adress of the Sole Shareholder was transfered to L-2212 Luxembourg, 6,
Place de Nancy.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
corporation incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately EUR 900,-.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above
appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
party, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Junglinster, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the mandatory of the appearing party, acting as said before, known to the notary
by name, first name, civil status and residence, the said mandatory has signed together with Us, the notary, the present
deed.
182543
L
U X E M B O U R G
suit la version en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille quatorze, le onze novembre.
Pardevant Nous Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
A COMPARU:
Boetie Luxco S.à r.l. société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2212 Luxem-
bourg, 6, Place de Nancy, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro B189.940,
ici représentée par ici représentée par Monsieur Henri DA CRUZ, employé, demeurant professionnellement à Jun-
glinster, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée; laquelle procuration, après avoir été signée “ne varietur”
par le mandataire et le notaire, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.
Laquelle partie comparante, par son mandataire, a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter les suivant:
- Que la société à responsabilité limitée.. Boetie Propco S.à r.l..., établie et ayant son siège social à L-2370 Howald, 1,
rue Peternelchen, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B numéro 189.940,
constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Paul MEYERS, notaire de résidence à Rambrouch, Grand-Duché de Luxem-
bourg en date du 27 août 2014, publié au Mémorial C numéro 2457 du 12 septembre 2014. Les statuts ont été modifiés
suivant acte reçu par Maître Jean-Paul MEYERS, notaire de résidence à Rambrouch, Grand-Duché de Luxembourg en
date du 29 septembre 2014, en voie de publication au Mémorial C.
- Que la partie comparante, représentée comme dit ci-avant, est la seule associée actuelle de la Société et qu'elle a
pris, par son mandataire, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de transférer l’adresse du siège social vers L-2212 Luxembourg, 6, Place de Nancy et de modifier
en conséquence de l’article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 4. Siège.
4.1 Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg.
4.2 Le siège social peut être transféré au sein de la commune par décision du conseil de gérance. Il peut être transféré
dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l’assemblée générale des associés, adoptée
selon les conditions requises pour une modification des présents statuts.
4.3 Des succursales ou bureaux peuvent être créés, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l’étranger, par décision
du conseil de gérance.
4.4 Dans l’hypothèse où le conseil de gérance estimerait que des événements exceptionnels d'ordre politique, éco-
nomique ou social ou des catastrophes naturelles se sont produits ou seraient imminents, de nature à interférer avec
l’activité normale de la Société à son siège social, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu'à
la cessation complète de ces circonstances exceptionnelles; ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur
la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.»
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide constate que l’adresse de l’Associé Unique a été transféré vers L-2212 Luxembourg, 6, Place de
Nancy.
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de EUR 900.-
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête de la partie
comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même partie comparante,
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Junglinster, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte au mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire
par nom, prénom, état civil et domicile, ledit mandataire a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: Henri DA CRUZ, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 17 novembre 2014. Relation GRE/2014/4486. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2014184014/105.
(140207790) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2014.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
182544
aeco atelier d'architecture
Ageney S.A.
Albali Invest S.A.
Al Dente S.A.
Alema S.A.
Alema S.A.
Alibaba Kebab Snack S. à r. l.
Alluxbau s.à r.l.
Ambassador Investment Allocation S.A.
Atrium International S.A.
Balmoral Land Luxembourg Sàrl
Bash, Vreugne & Associés S.A.
BB Fuel 04 S.àr.l.
Bernard Galonnier Investment Partners S.A.
Binnopharm International S.à r.l.
Boetie Propco S.à r.l.
Bridon SA
BV Capital Partners Luxemburg S.A.
Carey S.A.
Comptoir Technique et Industriel S.A.
Confédération Européenne de Volley-Ball
CS Energies SA
Edam Holding S.à r.l.
Elbblick (Delta) S.à r.l.
Elbblick (Juliet) S.à r.l.
Elbblick (Kilo) S.à r.l.
Foodco Invest S.à r.l.
HayFin Jade LuxCo 2 S.à r.l.
HayFin Jade LuxCo 3 S.à r.l.
Immobiliengesellschaft Edward Steichen Building Kirchberg S.A.
JP Commercial IX S.à r.l.
Key Note S.à r.l.
RP XIII S.àr.l.
RP XII S.àr.l.
RP XI S.à r.l.
RP X S.àr.l.
RT Holding S.à r.l.
SCI Schmideberg
Sotrilux Sàrl
Sport Distribution & Events Lux S.à r.l.
Stratcom S.à r.l.
Superbricolux S.A.
Supercell S.A.
Syan Corporate
SynerMesh S.A.
TalkingBird S.à r.l.
Tamweelview Listed Securities Holdings S. à r. l.
TENZING-Partners
TèrémeR, Sàrl
Thonex Villeneuve S.A.
Tomipal S.A.
T.O.Summit S.A.
Valentin DIEDRICH S.à r.l.
Vanguard Topco S.à r.l.
Van Neulen & Schmit S.A.
Vence Investment S.A.
Veneluxe S.A.
Venetie Ventures S.A.
Vitruvian II Luxembourg S.à r.l.
Westrich Gen S.A.
Wilsonart International Holdings S.à r.l.
Winsun Europe S.A.
Yellowstone S.A.