This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 3793
9 décembre 2014
SOMMAIRE
Bil Manage Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182053
Cameron LUX NOK Sàrl . . . . . . . . . . . . . . .
182019
Capinera S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182036
Diamar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182037
Digital Services XXIV 4 S.C.Sp . . . . . . . . . .
182027
Dundeal (International) 13 S.à r.l. . . . . . . .
182019
Fusion Funding Luxembourg S.à r.l. . . . . .
182018
Global Pharm S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182018
Groupe Résidences Pleine Vie S.A. . . . . . .
182022
GT-Sat International S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
182023
Gulf SAQR S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182021
Günter Mencher Soparfi S.à r.l. . . . . . . . . . .
182024
Halisol Groupe, S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182025
Halva S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182021
Haus + Technik s.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182026
HayFin DLF (Europe) Luxco 1 S.à r.l. . . . .
182021
HayFin DLF (Europe) Luxco 2 S.à r.l. . . . .
182022
HayFin DLF (Europe) Luxco 3 S.à r.l. . . . .
182024
Healthcare Real Estate S.à r.l. . . . . . . . . . . .
182026
Hero S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182021
Highstreet AcquiCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
182039
Hola Capital S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182024
House Concept S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182025
Hydratec SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182022
I.D.C.L. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182020
I.G. Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182026
Immobiliengesellschaft Edward Steichen
Building Kirchberg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
182024
Immo Impact S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182022
Industrielle Beteiligung S.A. . . . . . . . . . . . . .
182025
Ingersoll-Rand Lux Euro III Financing S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182023
Innovatec-Lubtrading S.A. . . . . . . . . . . . . . .
182025
Intech S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182026
International Car Rentals S.à r.l. . . . . . . . . .
182023
I.S.C. - International Sponsoring Corpora-
tion S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182023
Long Wave S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182020
LU-Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182035
Lutrac Constructions Sàrl . . . . . . . . . . . . . . .
182039
Marsh & McLennan Companies Holdings
(Luxembourg) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182028
MB2s S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182031
MCP III Investment S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
182059
MD International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182050
NPS RE Projects (Luxembourg) Holdings 2
Limited S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182018
NREP Transactions Holding 4 S.à r.l. . . . .
182019
NWL Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
182020
OCM Luxembourg ROF VI S.à r.l. . . . . . . .
182018
Pars Real Estate Foundation Sàrl . . . . . . . .
182039
Predica Infrastructure S.A. . . . . . . . . . . . . . .
182019
Professional Care Holding S.à r.l. . . . . . . . .
182018
RELOG Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
182028
Rollinger Promotion Immobilière S.A. . . .
182061
Ruco S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182064
Zamerhof Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
182022
182017
L
U X E M B O U R G
Professional Care Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 176.191.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014183704/9.
(140206203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2014.
OCM Luxembourg ROF VI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 175.220.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 novembre 2014.
Référence de publication: 2014179346/10.
(140205596) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2014.
Fusion Funding Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 141.099.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 novembre 2014.
Fusion Funding Luxembourg S.à r.l.
Référence de publication: 2014183418/11.
(140206779) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2014.
Global Pharm S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.
R.C.S. Luxembourg B 161.894.
<i>Rectificatif L-140204891i>
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 novembre 2014.
Référence de publication: 2014179189/11.
(140205807) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2014.
NPS RE Projects (Luxembourg) Holdings 2 Limited S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 153.436.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 novembre 2014.
TMF CORPORATE SERVICES S.A.
Signatures
Référence de publication: 2014179340/12.
(140205791) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2014.
182018
L
U X E M B O U R G
Predica Infrastructure S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 137.978.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 novembre 2014.
Référence de publication: 2014178732/10.
(140204995) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2014.
Dundeal (International) 13 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 9A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 174.674.
EXTRAIT
L'adresse professionnelle de M. George Valentini, gérant de catégorie A de la Société, est désormais la suivante: Suite
301, 30 Adelaide Street East, Toronto, Canada M5C 3H1.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
Dundeal (International) 13 S.à r.l.
Référence de publication: 2014183307/13.
(140206311) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2014.
NREP Transactions Holding 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 50.125,00.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 125.050.
<i>Extrait de la résolution des associés de NREP Transactions Holding 4 SARL (la «Société») du 17 novembre 2014:i>
Les associés de la Société ont décidé avec effet immédiat (i) d'accepter la démission de Mr Mark Raine en tant que
gérant B de la Société avec effet immédiat et (ii) de nommer Mr Steen Sønderby avec adresse professionnelle au 48 A
Skodsborgvej, 2830 Virum, Danemark, en tant que nouveau gérant B de la Société, avec effet immédiat et pour une période
indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014178690/14.
(140204298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2014.
Cameron LUX NOK Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: NOK 120.000,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 154.384.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associée unique en date du 31 octobre 2014i>
1. Madame Cécile JAGER a démissionné de son mandat de gérante avec effet au 31 octobre 2014.
2. Monsieur David CATALA, administrateur de sociétés, né à Gent Belgique le 19 janvier 1979, demeurant profes-
sionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommé comme gérant pour une durée indéterminée
avec effet au 31 octobre 2014.
Luxembourg, le 18 novembre 2014.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour CAMERON LUX NOK SARL
i>Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.
Référence de publication: 2014179070/17.
(140205531) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2014.
182019
L
U X E M B O U R G
Long Wave S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, Boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 113.144.
Le bilan et annexes au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014178602/10.
(140205044) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2014.
I.D.C.L. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 89.142.
<i>Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 19 juin 2014.i>
1. L'assemblée décide de renouveler le mandat de Monsieur Pascal HENNUY, demeurant professionnellement au 241,
Route de Longwy L-1941 Luxembourg au poste de commissaire aux comptes de la société, et ce jusqu'à l'assemblée à
tenir en 2020.
2. L'assemblée décide de renouveler les mandats d'administrateurs de Monsieur Tom DONOVAN, demeurant 79
Glenvara Park Knocklyon Dublin 16 Irlande, Madame Roisin DONOVAN, demeurant 79 Glenvara Park Knocklyon 79
Dublin 16 Irlande et Monsieur David KEOGH, demeurant Annamoe Road 25 Dublin 7 Irlande et ce jusqu'à l'assemblée
à tenir en 2020.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014184962/16.
(140208596) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2014.
NWL Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 106.345.
<i>Extrait des décisions de l'associé unique en date du 12 novembre 2014i>
Il ressort des décisions écrites prises en date du 12 novembre 2014 que l'associé unique de la Société a décidé:
1. de prendre acte de la démission de Madame Meredith G. Stevens de son mandat de gérant avec effet au 31 octobre
2014;
2. de nommer Madame Sophia Dong, de nationalité chinoise, née le 13 juillet 1970 à Tianjin (Chine), résidant profes-
sionnellement à Gubei International Fortune Center II, 10F, No. 1438, HongQiao Road, Shanghai 201103 (Chine) en tant
que gérant de la société avec effet au 12 novembre 2014 et pour une durée illimitée.
En conséquence, le conseil de gérance de la Société est désormais composé comme suit:
- Monsieur John K. Stipancich,
- Madame Sophia Dong,
- Monsieur Herman On,
- Monsieur Robbert Kempen, et
- Monsieur Richard Hyam.
Conformément aux dispositions de l'article 10 des statuts de la Société, la Société est valablement représentée à l'égard
des tiers et en justice par la signature individuelle de toute personne à laquelle de tels pouvoirs de signature auront été
délégués par le conseil de gérance.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 novembre 2014.
Signature
<i>Le Mandatairei>
Référence de publication: 2014178694/28.
(140204303) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2014.
182020
L
U X E M B O U R G
Halva S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 178.803.
Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Blanche MOUTRIER, agissant en
remplacement de notaire de résidence à Esch/Alzette, Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette en
date du 29 août 2014 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 29 septembre 2014.
Référence de publication: 2014184927/12.
(140208003) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2014.
Gulf SAQR S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 117.440.
Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 novembre 2014.
Luxembourg Corporation Company S.A.
Signature
<i>Gérant uniquei>
Référence de publication: 2014184922/13.
(140208419) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2014.
Hero S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7680 Waldbillig, 22, rue André Hentges.
R.C.S. Luxembourg B 141.027.
Le bilan au 31.12.2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 novembre 2014.
Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L-1013 Luxembourg
Référence de publication: 2014184955/14.
(140208233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2014.
HayFin DLF (Europe) Luxco 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 173.618.
<i>Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire du 24 novembre 2014:i>
- Est nommé gérant de classe B de la société pour une période indéterminée Mme. Nahima Bared, employée privée,
résidant professionnellement au 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg en remplacement du gérant dé-
missionnaire Mme. Heike Kubica, avec effet au 24 novembre 2014.
Luxembourg, le 24 novembre 2014.
Signatures
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2014184929/15.
(140208409) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2014.
182021
L
U X E M B O U R G
Immo Impact S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8079 Bertrange, 117A, rue de Leudelange.
R.C.S. Luxembourg B 109.096.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
IF EXPERTS COMPTABLES
B.P. 1832 L-1018 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2014184970/12.
(140208716) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2014.
Hydratec SA, Société Anonyme.
Siège social: L-8057 Bertrange, 13-15, rue du Chemin de Fer.
R.C.S. Luxembourg B 39.177.
EXTRAIT
Il résulte d'un courrier reçu daté du 5 novembre 2014 que Monsieur Francis Gehl démissionne avec effet immédiat
de ses mandats d'administrateur et d'administrateur délégué de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 novembre 2014.
<i>Pour Hydratec S.A.i>
Référence de publication: 2014184961/13.
(140208109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2014.
Groupe Résidences Pleine Vie S.A., Société Anonyme de Titrisation,
(anc. Zamerhof Holding S.A.).
R.C.S. Luxembourg B 144.247.
- Monterey Audit Sàrl, agent domiciliataire, dénonce le siège social de la société
Groupe Résidences Pleine Vie S.A., Société Anonyme de Titrisation,
(anc. Zamerhof Holding S.A.).
R.C.S. Luxembourg B 144.247.
et domiciliée au 29, Avenue Monterey L-2163 Luxembourg.
Luxembourg, le 1
er
novembre 2014.
Philippe GAIN
<i>Géranti>
Référence de publication: 2014184919/14.
(140208416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2014.
HayFin DLF (Europe) Luxco 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 173.620.
<i>Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire du 24 novembre 2014:i>
- Est nommé gérant de classe B de la société pour une période indéterminée Mme. Nahima Bared, employée privée,
résidant professionnellement au 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg en remplacement du gérant dé-
missionnaire Mme. Heike Kubica, avec effet au 24 novembre 2014.
Luxembourg, le 24 novembre 2014.
Signatures
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2014184930/15.
(140208410) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2014.
182022
L
U X E M B O U R G
I.S.C. - International Sponsoring Corporation S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6477 Echternach, 15, rue des Remparts.
R.C.S. Luxembourg B 55.018.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014184964/9.
(140208485) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2014.
GT-Sat International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7257 Helmsange, 16, Millewee.
R.C.S. Luxembourg B 104.210.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014184921/10.
(140208439) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2014.
Ingersoll-Rand Lux Euro III Financing S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 165.718.
EXTRAIT
La Société prend acte qu'une erreur a été commise dans le nom de Monsieur David Butow, gérant de catégorie A la
Société.
En effet, il y a lieu de lire Monsieur David Butow au lieu de Monsieur David Burow.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme,
Luxembourg, le 24 novembre 2014.
Référence de publication: 2014184966/15.
(140208142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2014.
International Car Rentals S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 191.724.
EXTRAIT
Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales en date du 30 octobre 2014 que:
- Investindustrial V L.P., associé, a cédé 125,000 parts sociales, ayant une valeur nominale de 0,10 euro chacune, à
international Car Rentals Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège
social au 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 191.735;
Désormais, l'associé de la Société est le suivant:
- International Car Rentals Holdings S.à r.l. détient 125,000 parts sociales d'une valeur nominale de 0,10 euro chacune.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
V. Boussard
<i>Géranti>
Référence de publication: 2014184967/20.
(140208301) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2014.
182023
L
U X E M B O U R G
Günter Mencher Soparfi S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5440 Remerschen, 34, Waïstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 136.728.
Der Jahresabschluss vom 31/12/2011 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014184924/9.
(140208011) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2014.
Hola Capital S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue de Zithe.
R.C.S. Luxembourg B 155.877.
Le siège sociale de la société a été changé du 41 avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg au 38-40, rue de St. Zithe
L-2763, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Sociétéi>
Référence de publication: 2014184956/11.
(140208731) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2014.
HayFin DLF (Europe) Luxco 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 173.665.
<i>Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire du 24 novembre 2014:i>
- Est nommé gérant de classe B de la société pour une période indéterminée Mme. Nahima Bared, employée privée,
résidant professionnellement au 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg en remplacement du gérant dé-
missionnaire Mme. Heike Kubica, avec effet au 24 novembre 2014.
Luxembourg, le 24 novembre 2014.
Signatures
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2014184931/15.
(140208411) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2014.
Immobiliengesellschaft Edward Steichen Building Kirchberg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2215 Luxembourg, 4, rue de Neuerburg.
R.C.S. Luxembourg B 89.167.
AUSZUG
Es geht aus dem Protokoll der ordentlichen Hauptversammlung vom 18. Juli 2014 hervor dass:
die Herren
- Frank Feldmann, Dipl.-Betriebswirt, Blumenstrasse 28, 45721 Haltern am See
- Bernhard Preckel, kfm. Angestellter, Klendergarten 3a, 48683 Ahaus
- Thomas Degener, Betriebswirt, Lucasstrasse 24, 45899 Gelsenkirchen
als Verwaltungsratsmitglieder bestimmt wurden.
- Fiduconcept SARL, mit Sitz in L-2132 Luxembourg, 36 Avenue Marie-Therese
als Kontenkommissar bestimmt wurde.
Die Mandate enden mit der nächsten jährlichen Generalversammlung der Aktionäre.
Luxemburg, den 21. November 2014.
<i>Für die Gesellschafti>
Référence de publication: 2014184973/19.
(140208201) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2014.
182024
L
U X E M B O U R G
House Concept S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7333 Steinsel, 70, rue des Prés.
R.C.S. Luxembourg B 91.821.
Statuts coordonnés suivant acte du 8 octobre 2014, reçu par Me Urbain THOLL, de résidence à Mersch, déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014184958/10.
(140208551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2014.
Halisol Groupe, S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 32-36, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 87.799.
Les comptes annuels au 30 avril 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 novembre 2014.
Référence de publication: 2014184926/10.
(140208334) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2014.
Industrielle Beteiligung S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1319 Luxembourg, 126, rue Cents.
R.C.S. Luxembourg B 43.599.
Le bilan, le compte de pertes et profits et les annexes au 30 juin 2014 ont été déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 novembre 2014.
<i>Pour la Sociétéi>
Référence de publication: 2014184965/12.
(140208071) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2014.
Innovatec-Lubtrading S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1617 Luxembourg, 66, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 109.641.
<i>Auszug der Beschlüsse der Generalversammlung vom 15. Oktober 2014i>
Die Generalversammlung hat folgende Beschlüsse gefasst:
<i>Beschluss 1:i>
Herr Nicolas LINDEN wurde als Verwaltungsratmitglied mit sofortiger Wirkung abberufen und durch Herrn Paul
KRIES ersetzt.
Die Generalversammlung nimmt die Ernennung von Herrn Paul KRIES als neues Verwaltungsratmitglied in Ablösung
von Herrn Nicolas LINDEN an.
<i>Beschluss 2:i>
Die Generalversammlung ernennt folgende Personen zu alleinigen Mitgliedern des Verwaltungsrats:
Frau Sylvie DELLERE, mit Berufsadresse in L-6415 Echternach, 9-13, rue Bréilekes.
Frau Claudine BICHLER-FISCHER, mit Berufsadresse in L-6415 Echternach, 9-13, rue Bréilekes.
Herr Paul KRIES, mit Berufsadresse in L-6415 Echternach, 9-13, rue Bréilekes.
Luxemburg, den 15. Oktober 2014.
Für gleichlautenden Auszug
<i>Die Gesellschafti>
Référence de publication: 2014184979/22.
(140208316) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2014.
182025
L
U X E M B O U R G
I.G. Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 66.562.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Référence de publication: 2014184963/10.
(140208291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2014.
Haus + Technik s.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9765 Mecher (Clervaux), Maison 3B.
R.C.S. Luxembourg B 98.007.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014184952/10.
(140208486) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2014.
Healthcare Real Estate S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1460 Luxembourg, 48, rue d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 179.477.
<i>Extrait des résolutions prises en date du 21 novembre 2014i>
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil de gérance en date du 21 novembre 2014, que:
- le nom du gérant Pascal Bruzzese doit être rectifié.
Luxembourg le 21 novembre 2014.
Pour extrait conforme
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2014184950/14.
(140208681) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2014.
Intech S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3850 Schifflange, 17-19, avenue de la Libération.
R.C.S. Luxembourg B 52.838.
<i>Extrait de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Intech S.A. tenue le 7 novembre 2014i>
L'assemblée générale des actionnaires accepte la démission de Monsieur François BOCCI de son poste de directeur
ainsi que la démission de Madame Nathalie CALBA de son poste de directeur technique.
Conformément à l'article 11 des statuts et l'article 60 de la loi du 10 août 1915, l'Assemblée Générale autorise le
Conseil d'Administration à déléguer tous ses pouvoirs en ce qui concerne la gestion journalière des affaires de la société
ainsi que la représentation de la société aux personnes suivantes:
<i>Au poste d'administrateur-déléguéi>
Monsieur Pierre ZIMMER, né le 12 août 1965 à Esch-sur-Alzette (L), demeurant professionnellement à L - 2020
Luxembourg, 8A, Avenue Monterey.
<i>Au poste de délégué à la gestion journalièrei>
Monsieur Fabrice CROISEAUX, né le 12 mars 1969 à Joeuf (F), demeurant professionnellement à L - 3850 Schifflange,
17-19, Avenue de la Libération.
Pour extrait sincère et conforme
Référence de publication: 2014184980/20.
(140208140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2014.
182026
L
U X E M B O U R G
Digital Services XXIV 4 S.C.Sp, Société en Commandite spéciale.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 191.876.
<i>Excerpts of the limited partnership agreement (the “Limited Partnership Agreement”) of Digital Services XXIV 4 S.C.SP, a speciali>
<i>limited partnership, executed on 14 October 2014i>
1. Partners who are jointly and severally liable. Digital Services XXIV (GP) S.à r.l., a société à responsabilité limitée
incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 5, Heienhaff,
L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register
under number B 188496 (the “General Partner”).
2. Name, Partnership’s Purpose, Registered Office, Business Year.
(i) Name
The special limited partnership shall have the name: Digital Services XXIV 4 S.C.SP (the “Partnership”).
(ii) Purpose
The purpose of the Partnership is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign
companies, limited partnerships or other arrangements and in any other form of investment, the acquisition by purchase,
subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and
the administration, management, control and development of its portfolio in order to further the development, marketing
and provision of internet services through such domestic and foreign subsidiaries (ecommerce covering goods and services
of different kinds) and the provision through its foreign subsidiaries of logistic services, digital services and all other services
relating to the aforementioned business.
The Partnership may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds
a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the Partnership.
The Partnership is entitled to pursue any and all activities which directly or indirectly serve its purpose. The Partnership
exercises any and all rights and obligations which pertain to any shares or interests in other companies.
(iii) Registered Office
The Partnership shall have its registered office at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
(iv) Business Year
The business year of the Partnership shall be the calendar year.
3. Designation of the manager and signatory powers. The management of the Partnership is incumbent upon the
General Partner.
The General Partner shall manage the Partnership on the basis of the provisions of the Partnership Agreement and
otherwise in the best interest of the Partnership. Any liability of the General Partner vis-à-vis the Partnership or its
Partners shall be limited to willful misconduct (dol) and gross negligence (négligence grave).
The Partnership is validly bound vis-à-vis third parties by the signature of the General Partner that represents it.
4. Date on which the Partnership commences and the date on which it ends. The Partnership commences as from 14
October 2014, for an indefinite term.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:
<i>Auszüge aus dem Gesellschaftsvertrag (dem „Limited Partnership Agreement“) der Digital Services XXIV 4 S.C.SP, einer Partner-i>
<i>schaftsgesellschaft nach Luxemburgischen Recht (Special Limited Partnership), geschlossen am 14 Oktober 2014i>
1. Gesellschafter, die unmittelbar und gesamtschuldnerisch haften. Digital Services XXIV (GP) S.à r.l., eine Gesellschaft
mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), welche den Bestimmungen des Gesetzes des Großherzogtums
Luxemburg unterliegt, mit Geschäftssitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen
im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) unter der Nummer B
188496 (die „Komplementärin“).
2. Name, Zweck der Gesellschaft, Sitz, Geschäftsjahr.
(i) Name
Die Gesellschaft heißt: Digital Services XXIV 4 S.C.SP (die „Gesellschaft“)
(ii) Zweck der Gesellschaft
Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Gesell-
schaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder
auf andere Weise sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form, die Verwaltung, Kontrolle und
Entwicklung ihrer Beteiligungen im Hinblick auf die Entwicklung, das Marketing und die Erbringung von Internetdienst-
leistungen durch heimische und ausländische Tochtergesellschaften (im Bereich ECommerce bezüglich Waren und
182027
L
U X E M B O U R G
Dienstleistungen jeglicher Art) sowie die Erbringung von Logistikdienstleistungen durch ausländische Tochtergesellschaf-
ten, Digitaldienstleistungen und allen anderen Dienstleistungen, die mit der zuvor genannten Geschäftstätigkeit im
Zusammenhang stehen.
Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, an denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder
Rechte jeglicher Art hält oder die der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören, Garantien geben, Sicher-
heiten einräumen, Darlehen gewähren oder die Gesellschaften auf jede andere Weise unterstützen.
Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten ausüben, die direkt oder indirekt ihrem Zweck dienen. Die Gesellschaft kann
jegliche Rechte und Pflichten in Bezug auf Beteiligungen an anderen Gesellschaften ausüben.
(iii) Sitz
Der Sitz der Gesellschaft ist in der rue 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
(iv) Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr wird das Kalenderjahr sein.
3. Wahl des Geschäftsführers und Zeichnungsbefugnisse. Die Geschäftsführung der Gesellschaft obliegt der amtie-
renden Komplementärin.
Die Komplementärin wird die Gesellschaft auf Basis der Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages oder in sonstiger
Weise bestmöglich im Interesse der Gesellschaft führen. Jede Haftung der Komplementärin gegenüber der Gesellschaft
wird auf Fälle des Vorsatzes (dol) und der groben Fahrlässigkeit (négligence grave) beschränkt.
Die Gesellschaft wird durch die Unterschrift der Komplementärin, durch welche die Gesellschaft repräsentiert wird,
rechtskräftig gegenüber Dritten verpflichtet.
4. Anfang und Enddatum der Gesellschaft. Die Gesellschaft wird am 14 Oktober 2014 für eine unbegrenzte Dauer
gegründet.
Référence de publication: 2014177496/78.
(140204022) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2014.
RELOG Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.600,00.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 132.481.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour RELOG Holding S.à r.l.
Mandatairei>
Référence de publication: 2014183764/11.
(140206099) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2014.
Marsh & McLennan Companies Holdings (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 171.057.
In the year two thousand and fourteen, on the six day of November.
Before Us Me Jean SECKLER, notary residing Junglinster, (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned.
There appeared:
MMC International Holdings LLC, a Delaware limited liability company having its principal place of business at c/o
Corporation Trust Company, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, 19801, USA;
Hereafter duly represented by Isabelle CHARLIER, lawyer, professionally residing at 69, Boulevard de la Pétrusse,
L-2320 Luxembourg, by virtue of proxy given under private seal.
The said powers of attorney, having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, will remain
attached to the present deed to be filed conjoined with the Luxembourg Trade and Companies’ Register.
The appearing party, represented as here above stated, has requested the undersigned notary to state that he is the
owner of all the corporate units (the “Sole Member”) of the company “Marsh & McLennan Companies Holdings (Lu-
xembourg) S.à r.l.”, having its registered office at 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, registered with the Luxembourg
Trade and Companies’ Register under the number B 171057 (the “Company”), incorporated by a deed of Maître Martine
SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg on August 13, 2012, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et
Associations number 2433 dated September 29, 2012 page 116740, which articles of association have amended since on
November 4, 2014 by a deed of the undersigned notary, not yet published.
182028
L
U X E M B O U R G
Thus, the Sole Member of the Company, represented as hereabove stated, requested the undersigned notary to state
the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Member resolves to increase the corporate capital of the Company by an amount of seven hundred sixty
million nine hundred forty-eight thousand United States Dollars (USD 760,948,000), so as to bring it from its present
amount of seven hundred ninety-one million six hundred sixty-two thousand United States Dollars (USD 791,662,000)
represented by forty thousand (40,000) ordinary shares with a nominal value of one United States Dollar (USD 1) (the
“Ordinary Shares”) and by seven hundred ninety-one million six hundred twenty-two thousand (791,622,000) mandatorily
redeemable preferred shares, each with a nominal value of one United States Dollar (USD 1) (the “MRPS”), to the amount
of one billion five hundred fifty-two million six hundred ten thousand United States Dollars (USD 1,552,610,000) repre-
sented by forty thousand (40,000) Ordinary Shares, each with a nominal value of one United States Dollar (USD 1) and
by one billion five hundred fifty-two million five hundred seventy thousand (1,552,570,000) MRPS, each with a nominal
value of one United States Dollar (USD 1) and having the rights and obligations as set forth in the present resolutions.
<i>Subscription and Paymenti>
There now appears Maître Isabelle Charlier, prenamed, acting in her capacity as duly appointed attorney in fact of the
company MMC International Holdings LLC, prenamed, represented as here above stated, declares subscribing in its name
and on its behalf to the newly issued seven hundred sixty million nine hundred forty-eight thousand (760,948,000) MRPS
with a nominal value of one United States Dollar (USD 1) each, having the rights and obligations as stated in the present
resolutions for an aggregate value of seven hundred sixty million nine hundred forty-eight thousand United States Dollars
(USD 760,948,000) and to make payment in full for such new MRPS by a contribution in kind consisting in the exchange
and transfer by the Sole Member of one hundred thirty point fifty-six (130.56) shares of the Sole Member amounting to
seven hundred sixty million nine hundred forty-eight thousand United States Dollars (USD 760,948,000) (the “Sole Mem-
ber Shares”) (the “Subscription”)
It results from a valuation report dated November 6, 2014, issued by Mr. Joseph P. Gigliotti for and on behalf of the
Sole Member (the “Valuation Report”) that the value of the Sole Member Shares corresponds at least to the number and
value of the newly issued MRPS.
Having acknowledged the above described Subscription, the Sole Member, represented as stated above, expressly
agreed with the description of the Subscription, its valuation and confirmed the validity of the Subscription and payment.
The Sole Member, represented as stated above, still declares that there is no legal or conventional limitation in the
transfer of the Sole Member Shares to the Company.
The value of the Sole Member Shares has been approved by the board of managers of the Company.
<i>Second resolutioni>
The Sole Member resolves to amend article 5, first paragraph, of the articles of association of the Company which
shall henceforth be read as follows:
“The subscribed capital of the Company is set at one billion five hundred fifty-two million six hundred ten thousand
United States Dollars (USD 1,552,610,000), represented by forty thousand (40,000) ordinary shares with a nominal value
of one United States Dollar (USD 1) each (the “Ordinary Shares”) and by one billion five hundred fifty-two million five
hundred seventy thousand (1,552,570,000) mandatorily redeemable preferred shares, each with a nominal value of one
United States Dollar (USD 1) (the “MRPS”).
<i>Third resolutioni>
The Sole Member resolves to authorize any manager of the Company to do everything necessary and incidental to
the above resolutions.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever borne by the Company, as a result of the presently
stated, are evaluated at approximately EUR 6,800.-.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the appearing parties, the
present deed is worded in English, followed by a French translation; at the request of the same appearing parties and in
case of divergence between the English and the French text, the English text shall prevail.
WHEREOF the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of the
document.
The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, the said proxyholder signed together
with the notary the present deed.
182029
L
U X E M B O U R G
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quatorze, le six novembre.
Pardevant Nous Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
A COMPARU:
MMC International Holdings LLC, une société du Delaware ayant son siège social à c/o Corporation Trust Company,
1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, 19801, USA, dûment représentée par Maître Isabelle CHARLIER, avocat,
demeurant professionnellement au 69, Boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée
sous seing privé.
La procuration, signée "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera
annexée au présent acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités de l’enregistrement.
Ladite partie comparante, représentée de la manière décrite ci-dessus, a demandé au notaire instrumentant de noter
qu’elle détient toutes les parts sociales (l’»Associé Unique») de la société «Marsh & McLennan Companies Holdings
(Luxembourg) S.à r.l.», une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à 74, Rue de Merl, L-2146 Luxembourg,
immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro 171057 (la «Société»)
constituée suivant acte reçu par Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg en date du 12 août
2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, sous le numéro 2433 en date du 20 septembre 2012,
page 116740 et dont les statuts ont pas été modifiés le 4 novembre 2014 suivant acte reçu du notaire instrumentant, non
encore publié..
L’Associé Unique de la Société, représenté comme décrit ci-dessus a demandé au notaire instrumentant de noter les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Associé Unique décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de sept cent soixante millions neuf
cent quarante-huit mille Dollars Américains (USD 760.948.000), afin de le porter de son montant actuel de sept cent
quatre-vingt-onze millions six cent soixante-deux mille Dollars Américains (USD 791.662.000) représenté par quarante
mille (40.000) parts ordinaires ayant une valeur nominale d’un Dollar Américain (USD 1) (les «Parts Ordinaires») et par
sept cent quatre-vingt-onze millions six cent vingt-deux mille (791.622.000) parts privilégiées obligatoirement rachetables
d’une valeur nominale d’un Dollar Américain (USD 1) chacune (ci-après les «PPORs»), à un montant d’un milliard cinq
cent cinquante-deux millions six cent dix mille Dollars Américains (USD 1.552.610.000) représentés par quarante mille
(40.000) Parts Ordinaires, ayant chacune une valeur nominale d’un Dollar Américain (USD 1) et d’un milliard cinq cent
cinquante-deux millions cinq cent soixante-dix mille (1.552.570.000) PPORs, ayant chacune une valeur nominale d’un
Dollar Américain (USD 1) et ayant les droits et obligations tels que décris dans les présentes résolutions.
<i>Souscription et Paiementi>
Apparaît maintenant Maître Isabelle CHARLIER, prénommée, agissant en sa qualité de mandataire dûment nommée
par MMC International Holdings LLC, prénommé, représenté tel que décrit ci-dessus, déclare souscrire en son nom et
pour son compte à sept cent soixante mille neuf cent quarante-huit mille (760.948.000) PPORs nouvellement émises
ayant chacune une valeur nominale d’un Dollar Américain (USD 1), ayant les droits et obligations tels que décris dans les
présentes résolutions, pour une valeur totale de sept cent soixante millions neuf cent quarante-huit mille Dollars Amé-
ricains (USD 760.948.000) et en paiement de la totalité de ces PPORs nouvellement émises, à travers une contribution
en nature en échange et par le transfert par l’Associé Unique de cent trente virgule cinquante-six (130,56) actions de
l’Associé Unique s’élevant à sept cent soixante millions neuf cent quarante-huit mille Dollars Américains (USD
760.948.000) (les «Actions de l’Associé Unique») (la «Souscription»).
Il ressort d’un rapport d’évaluation en date du 6 novembre 2014, émis par Monsieur Joseph P. Gigliotti, au nom et
pour le compte de l’Associé Unique (le «Rapport d’Evaluation») que la valeur des Actions de l’Associé Unique correspond
au moins au nombre et à la valeur des PPORs nouvellement émises.
Ayant pris connaissance de la Souscription décrite ci-dessus, l’Associé Unique, représenté tel qu’indiqué ci-dessus,
approuve la description de la Souscription, son évaluation et confirme la validité de la Souscription et le paiement.
L’associé Unique, tel que décrit ci-dessus, déclare également qu’il n’y a aucune limite légale ou conventionnelle au
transfert des Actions de l’Associé Unique à la Société.
La valeur des Actions de l’Associé Unique a été approuvée par le conseil de gérance de la Société.
<i>Second résolutioni>
L’Associé Unique décide de modifier l’article 5, paragraphe 1 des Statuts de la Société qui doit être lu comme suit:
«Le capital social de la Société est fixé à un milliard cinq cent cinquante-deux millions six cent dix mille Dollars Amé-
ricains (USD 1.552.610.000) représenté par quarante mille (40.000) parts ordinaires d’une valeur nominale d’un Dollar
Américain (USD 1) chacune (ci-après les "Parts Ordinaires") et par un milliard cinq cent cinquante-deux millions cinq cent
soixante-dix mille (1.552.570.000) parts privilégiées obligatoirement rachetables d’une valeur nominale d’un Dollar Amé-
ricain (USD 1) chacune (ci-après les «PPORs»).»
182030
L
U X E M B O U R G
<i>Troisième résolutioni>
L’Associé Unique décide d’autoriser tout gérant de la Société d’effectuer toutes les formalités nécessaires en relation
avec les présentes résolutions.
<i>Fraisi>
Les frais, coûts, rémunérations et charges de quelque nature que ce soit incombant à la Société en raison du présent
acte, sont estimés approximativement à 6.800,- EUR.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par le présent acte qu'à la requête des parties compa-
rantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes parties comparantes et
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et lecture faite au mandataire des parties comparantes, ledit mandataire a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Isabelle CHARLIER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 12 novembre 2014. Relation GRE/2014/4429. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2014177785/147.
(140203605) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2014.
MB2s, MB2s S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 191.861.
STATUTEN
Im Jahre zweitausendvierzehn, den sechsten November.
Vor dem unterzeichneten Maître Jean SECKLER, Notar mit dem Amtssitz in Junglinster, (Großherzogtum Luxemburg);
IST ERSCHIENEN:
D.A.L. Holding SA SPF, Aktiengesellschaft zur Verwaltung von Familienvermögen ("société de gestion de patrimoine
familial", abgekürzt "SPF") L-1273 Luxemburg, 19, rue de Bitbourg, eingetragen beim Handelsund Gesellschaftsregister
von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 17.995,
Die Komparentin ist hier vertreten durch Frau Cristiana VALENT, Angestellte, beruflich ansässig in Junglinster, auf-
grund einer ihr erteilten Vollmacht unter Privatschrift.
Vorerwähnte Vollmacht, durch den Bevollmächtigten und den amtierenden Notar „ne varietur“ unterschrieben, bleibt
gegenwärtiger Urkunde beigefügt um mit derselben einregistriert zu werden.
Welche Komparentin, namens handelnd wie hiervor erwähnt, den amtierenden Notar ersuchen die Satzung einer
Aktiengesellschaft, welche sie hiermit gründen, zu beurkunden wie folgt:
Titel I. - Name, Sitz, Zweck, Dauer der gesellschaft
Art. 1. Es besteht eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung.“MB2s SA”., abgekürzt.“MB2s”. (hiernach die "Ge-
sellschaft"), geregelt durch die jeweiligen Gesetzesbestimmungen sowie die gegenwärtigen Statuten (die "Statuten").
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg) festgelegt.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Filialen, Agenturen oder Büros sowohl im
Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.
Unbeschadet der Regeln des allgemeinen Rechtes betreffend die Kündigung von Verträgen, falls der Gesellschaftssitz
auf Grund eines Vertrages mit Drittpersonen festgesetzt wurde, kann, durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates,
der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der Gemeinde Luxemburg verlegt werden.
Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss der Generalversammlung an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum
verlegt werden.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist es, Patente, Patentrechte, Marken, Warenzeichen, Markenschutzrechte, Lizenzen
und andere Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, gewähren und veräußern.
Die Gesellschaft kann ebenfalls sowohl in Luxemburg als auch im Ausland gelegene Immobilien erwerben, belasten,
halten, verwalten, verwerten und veräußern.
Des Weiteren ist der Gesellschaftszweck die Beteiligung an Unternehmen und Gesellschaften jedweder Art und die
Gründung, Entwicklung, Verwaltung und Kontrolle von Unternehmen und Gesellschaften. Die Gesellschaft kann ihre
182031
L
U X E M B O U R G
Beteiligungen durch Zeichnung, Erbringung von Einlagen, Ausübung von Kaufoptionen oder in sonstiger Art und Weise
erwerben und durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder in sonstiger Art und Weise verwerten.
Die Gesellschaft kann ihre Mittel zur Schaffung, Verwaltung, Entwicklung und Verwertung eines Portfolios verwenden,
welches sich aus Wertpapieren und Patenten jedweder Art und Herkunft zusammensetzen kann. Sie kann dabei alle Arten
von Wertpapieren durch Ankauf, Zeichnung oder in sonstiger Art und Weise erwerben und diese durch Verkauf, Ab-
tretung oder Tausch oder in sonstiger Weise veräußern.
Die Gesellschaft kann Unternehmen, an denen sie beteiligt ist oder ein wirtschaftliches Interesse hat, wie auch Un-
ternehmen, die zu der gleichen Gruppe gehören, unter Vorbehalt und Beachtung der diesbezüglich zur Anwendung
gelangenden gesetzlichen Bestimmungen, und ohne insoweit Geschäfte zu tätigen, die Bankgeschäfte oder Geschäfte des
Finanzsektors sind, Darlehen, Vorschüsse oder Sicherheiten gewähren und diese in jedweder Art und Weise zu unters-
tützen. Sie kann darüber hinaus Darlehen mit oder ohne Garantie aufnehmen und Hypotheken, Pfandrechte und sonstige
Sicherheiten aller Art zugunsten ihrer eigenen Gläubiger oder zugunsten von Gläubigern von Unternehmen der vorbe-
zeichneten Art bestellen.
Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit oder
ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüglichen
gesetzlichen Bestimmungen.
Die Gesellschaft kann außerdem alle anderen Operationen kommerzieller, industrieller, finanzieller, mobiliarer und
immobiliarer Art, welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern, ausfüh-
ren.
Titel II. - Kapital, Aktien
Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt einunddreißigtausend Euro (31.000,- EUR), eingeteilt in
einhundert (100) Aktien mit einem Nominalwert von je dreihundertzehn Euro (310,- EUR).
Der Verwaltungsrat oder der Einzelvorstand, wie vorhanden, ist autorisiert, weitere Kapitalreserven zu bilden, wie er
es von Zeit zu Zeit für notwendig erachtet (zusätzlich zu denen vom Gesetz verlangten) und er soll eingezahlte Über-
schüsse, welche die Gesellschaft als Aktienagio oder aus dem Verkauf von Aktien erhält, nutzen, um realisierte oder nicht
realisierte Kapitalverluste aufzurechnen oder Dividenden oder andere Ausschüttungen zu zahlen.
Die Aktien lauten sind Inhaber oder Namensaktien, nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien, für welche
das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.
Die Aktien können, auf Anfrage der Aktionäre, durch Aktienzertifikate repräsentiert werden, welche einzelne oder
mehrere Aktien umfassen können.
Die Gesellschaft kann, im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingungen, ihre eigenen Aktien
erwerben.
Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder reduziert werden, durch Beschluss der Generalver-
sammlung der Aktionäre, welcher unter den gleichen Bedingungen wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist.
Titel III. - Verwaltung
Art. 6. Die Gesellschaft wird durch den Verwaltungsrat, bestehend aus mindestens drei (3) Mitgliedern, geleitet, welche
Aktionäre sein können.
Sollte die Gesellschaft nur einen Einzelaktionär haben, so kann lediglich ein (1) Einzelvorstand die Geschäfte der Ge-
sellschaft führen, unabhängig davon, ob er eine natürliche oder juristische Person ist.
Sofern in dieser Satzung nicht anders vorgesehen, sind alle Vollmachten und Kompetenzen, welche dem Verwaltungsrat
zugewiesen werden, auch dem Einzelvorstand zugewiesen, sofern ein solcher gewählt wurde.
Sollte ein Vorstandsmitglied oder Einzelvorstand eine juristische Person sein, so ernennt dieser Vorstand einen stän-
digen Vertreter (der "Ständige Vertreter"), welcher in Luxemburg residiert.
Die Mitglieder des Verwaltungsrates oder der Einzelvorstand werden durch die Generalversammlung der Aktionäre
für eine Dauer von höchstens sechs (6) Jahren gewählt, wobei die Generalversammlung die Mitglieder jederzeit abberufen
kann.
Die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder, die Dauer ihres Mandats sowie ihre Entschädigung werden durch die Ge-
neralversammlung der Aktionäre festgesetzt.
Das Amt eines Verwaltungsratsmitglieds gilt als unbesetzt wenn:
- er von seinem Posten unter schriftlicher Benachrichtigung der Gesellschaft zurücktritt, oder
- seinen Posten aufgrund rechtlicher Vorschriften niederlegen muss weil es ihm durch diese Vorschriften verboten ist
oder er als unqualifiziert gilt, diesen Posten weiterhin auszuüben;
- er zahlungsunfähig wird oder generell Absprachen oder einvernehmliche Regelungen mit seinen Gläubigern trifft,
oder.
- wenn er von seinem Posten durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre enthoben wird.
182032
L
U X E M B O U R G
Sofern das Gesetz es erlaubt, soll jedes aktuelle oder ehemalige Mitglied des Verwaltungsrates aus dem Vermögen der
Gesellschaft für jeglichen Verlust oder Haftung entschädigt werden, welche ihm aufgrund der Ausübung seines Mandats
als Mitglied entstanden sind.
Art. 7. Sofern er existiert, wählt der Verwaltungsrat aus seiner Mitte einen Vorsitzenden.
Auf Einberufung durch den Vorsitzenden trifft sich der Verwaltungsrat so oft wie es im Interesse der Gesellschaft
notwendig ist. Der Verwaltungsrat muss zusammentreten, wenn ein (1) Vorstandsmitglied dies verlangt.
Alle Verwaltungsratssitzungen werden in Luxemburg abgehalten.
Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, sofern die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.
In dringlichen Fällen können Beschlüsse auch auf schriftlichem Wege gefasst werden (Umlaufbeschlüsse). Solche Bes-
chlüsse haben dieselbe Wirksamkeit und Auswirkungen wie Beschlüsse einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehal-
tenen Verwaltungsratssitzung, wenn alle Mitglieder des Verwaltungsrates oder der Einzelvorstand sie unterzeichnet haben.
Die Unterschriften der Mitglieder in einem Umlaufbeschluss können auf einem Dokument oder auf mehreren Kopien
eines gleich lautenden Beschlusses erscheinen und können im Wege eines Briefes, Fax oder ähnlichen Kommunikations-
mittels erbracht werden. Umlaufbeschlüsse sollen an den Sitz der Gesellschaft übersendet werden und dort aufbewahrt
werden.
In dringlichen Fällen können Mitglieder des Verwaltungsrates Sitzungen auch durch Verwendung von Fernkommuni-
kationsmitteln abhalten. Nimmt ein Mitglied an einer solchen Sitzung durch ein Fernkommunikationsmittel (einschließlich
eines Telefons) teil, so muss sichergestellt sein, dass alle anderen an der Sitzung teilnehmenden Mitglieder (die entweder
anwesend sind oder sich ebenfalls eines Ferntelekommunikationsmittels bedienen) dieses Mitglied hören und selbst von
diesem Mitglied gehört werden können. In einem solchen Fall gelten Mitglieder, die sich eines Fernkommunikationsmittels
bedienen als an dieser Sitzung teilnehmende Mitglieder, die für die Zählung des Quorums maßgeblich sind und wirksam
über alle auf einer solchen Sitzung besprochenen Angelegenheiten abstimmen können.
Art. 8. Der Einzelvorstand oder der Verwaltungsrat ist befugt, die Gesellschaft im weitesten Sinne zu leiten und alle
Geschäfte vorzunehmen, welche mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen.
Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder diese Satzung der Generalversammlung zustehen, fallen
in den Aufgabenbereich des Verwaltungsrates oder des Einzelvorstandes.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, im Einklang mit den rechtlichen Vorschriften Zwischendividenden auszuzahlen.
Art. 9. Wenn ein Verwaltungsrat besteht, wird die Gesellschaft rechtmäßig vertreten durch die Einzelunterschrift des
Delegierten des Verwaltungsrates der Gesellschaft, welches qualifiziert ist die hiervor im Gesellschaftszweck beschrie-
benen Aktivitäten auszuüben, gemäß den vorgeschriebenen Kriterien des luxemburgischen Mittelstandsministerium, oder
durch die gemeinsame Unterschrift des Delegierten des Verwaltungsrates und eines anderen Verwaltungsratsmitgliedes.
Sollte lediglich ein Einzelvorstand existieren, wird die Gesellschaft durch die Unterschrift des Einzelvorstandes rechtlich
wirksam gebunden. Ist der Einzelvorstand eine juristische Person, so soll deren Unterschrift im Einklang mit ihren Ge-
sellschaftsdokumenten und existierenden Autorisation abgegeben werden. Diese juristische Person, welche Einzelvors-
tand ist, kann den Ständigen Vertreter autorisieren, im Namen der Gesellschaft zu zeichnen.
Art. 10. Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse zur Führung des Tagesgeschäfts an einen oder mehrere seiner
Mitglieder, die geschäftsführenden Mitglieder, delegieren.
Der Verwaltungsrat kann weiterhin die Verwaltung aller Angelegenheiten der Gesellschaft oder der Angelegenheiten
eines bestimmten Sachgebietes einem oder mehrerer seiner Mitglieder zuweisen und für bestimmte Angelegenheiten
Sondervollmachten an andere Personen erteilen, die weder Verwaltungsratsmitglieder noch Aktionäre der Gesellschaft
sein müssen.
Art. 11. Der Verwaltungsrat, durch seinen Vorsitzenden oder einen für diesen Zweck bevollmächtigtes Mitglied des
Verwaltungsrates, oder der Einzelvorstand, falls vorhanden, vertritt die Gesellschaft in allen Rechtsstreitigkeiten im Na-
men der Gesellschaft.
Titel IV. - Aufsicht
Art. 12. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Rechnungskommissare beaufsichtigt. Rechnungskommissare
werden durch die Generalversammlung der Aktionäre oder den Einzelaktionär, im gegebenen Falle, ernannt, welche(r)
auch die Anzahl der Rechnungskommissare, ihre Entschädigung und die Dauer ihrer Bestellung, welche sechs (6) Jahre
nicht überschreiten darf, bestimmt.
Titel V. - Generalversammlung
Art. 13. Die jährliche Generalversammlung findet am letzten Montag des Monats Juni um 10.00 Uhr am Gesellschaftssitz
oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort, statt.
Sollte ein solcher Tag ein gesetzlicher Feiertag sein, wird die Generalversammlung am nächstfolgenden Arbeitstag
stattfinden.
Alle außerordentlichen Generalversammlungen finden ebenfalls in Luxemburg statt.
182033
L
U X E M B O U R G
Die Generalversammlung kann wirksam Beschlüsse fassen, wenn die einfache Mehrheit der anwesenden und vertre-
tenen Aktionäre auf einer jährlichen oder außergewöhnlichen Generalversammlung zustimmt, es sei denn, das Gesetz
oder diese Satzung sehen andere Mehrheits- und Quorumserfordernisse vor.
Titel VI. - Geschäftsjahr / Gewinnverwertung
Art. 14. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 15. Nach Abzug jeglicher Ausgaben der Gesellschaft und Amortisierungen, weist die Bilanz der Gesellschaft ihren
Nettogewinn aus.
Fünf Prozent (5%) des Nettogewinns werden als gesetzliche Rücklage abgeführt. Diese zwangsweise Abführung endet
sobald die gesetzliche Rücklage einen Wert von zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft erreicht
hat. Sollte die gesetzliche Rücklage unter diesen Wert sinken, muss die zwangsweise Abführung wieder aufgenommen
werden bis die gesetzliche Rücklage wieder vollständig aufgefüllt ist.
Über den verbleibenden Nettogewinn kann die Generalversammlung der Aktionäre oder der Einzelaktionär, wie vo-
rhanden, frei verfügen.
Titel VII. - Auflösung und Liquidation
Art. 16. Die Gesellschaft kann jederzeit, durch einen Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre oder des
Einzelaktionärs aufgelöst werden. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren
Liquidatoren durchgeführt, die natürliche oder juristische Personen sein können und von der Generalversammlung bestellt
werden. Die Generalversammlung bestimmt die Befugnisse und die Entschädigung des bzw. der Liquidatoren.
Titel VIII. - Allgemeine Vorschriften
Art. 17. Alle Angelegenheiten, die nicht in dieser Satzung geregelt werden, unterliegen den Vorschriften des Gesetzes
vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften und den Änderungsgesetzen zu diesem Gesetz.
<i>Vorübergehende Bestimmungeni>
1. Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2014.
2. Die erste jährliche Generalversammlung findet im Jahre 2015 statt.
3. Ausnahmsweise kann der erste Vorsitzende sowie der (die) erste(n) Delegierte(n) des Verwaltungsrates von der
ersten Generalversammlung, welche den ersten Verwaltungsrat bestellt, ernannt werden.
<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktieni>
Nach Feststellung der Statuten, wie vorstehend erwähnt, wurden alle Aktien durch die alleinige Aktionärin, die Ge-
sellschaft D.A.L. Holding SA SPF, vorgenannt, gezeichnet und voll in bar eingezahlt, so dass der Betrag von einunddreißig-
tausend Euro (31.000,- EUR) zur Verfügung steht, durch eine Bankbescheinigung ausdrücklich nachgewiesen wurde.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar erklärt, dass die Bedingungen des Artikels 26 des Gesetzes vom 10. August 1915, wie
abgeändert, beachtet und erläutert wurden.
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr 1.250,-EUR.
<i>Beschlüsse der Alleingesellschafterini>
Unverzüglich nach der Gründung der Gesellschaft, hat die erschienen Partei, welche das gesamte gezeichnete Gesell-
schaftskapital vertritt, als Alleingesellschafterin folgende Beschlüsse gefasst:
1) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1273 Luxemburg, 19, rue de Bitbourg.
2) Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei (3) und die der Kommissare auf einen (1) festgesetzt.
a) Herrn Martin DRESCHER, Geschäftsführer, geboren in Saarbrücken (Bundesrepublik Deutschland), am 26. De-
zember 1962, beruflich wohnhaft in L-1273 Luxemburg, 19, rue de Bitbourg.
b) Herr Gernot KOS, Steuerberater, geboren in Eisenstadt, (Österreich), am 23. Januar 1970, beruflich wohnhaft in
L-1273 Luxemburg, 19, rue de Bitbourg.
c) Herr Thierry HELLERS, Steuerberater, geboren in Luxemburg, am 13. September 1968, beruflich wohnhaft in L-1273
Luxemburg, 19, rue de Bitbourg.
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung.“G.T. Fiduciaires SA”, mit Sitz in L-1273 Luxemburg, 19, rue de Bitbourg,
eingetragen beim Handelsund Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 121820, wird zum
Kommissar bestellt.
6) Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Generalver-
sammlung von 2020.
182034
L
U X E M B O U R G
WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Vertreter der erschienenen Partei, namens handelnd
wie hiervor erwähnt, dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort be-
kannt, hat derselbe mit Uns dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: Cristiana VALENT, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 11 novembre 2014. Relation GRE/2014/4413. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2014177805/207.
(140203766) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2014.
LU-Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2732 Luxembourg, 2, rue Wilson.
R.C.S. Luxembourg B 147.074.
L'an deux mille quatorze, le vingt-deuxième jour du mois d'octobre;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné;
S’est réunie
l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l’“Assemblée”) de la société anonyme “LU-INVEST”, établie et
ayant son siège social à L-2732 Luxembourg, 2, rue Wilson, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Lu-
xembourg, section B, sous le numéro 147074, (la “Société”), constituée suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER,
notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 3 juillet 2009, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 1477 du 30 juillet 2009,
et dont les statuts (les “Statuts”) n'ont plus été modifiés depuis lors.
L'Assemblée est présidée par Madame Monique GOERES, employée, demeurant professionnellement à L-1466 Lu-
xembourg, 12, rue Jean Engling.
La Présidente désigne comme secrétaire et l’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Christian DOSTERT,
employée, demeurant professionnellement à L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.
Le bureau ayant ainsi été constitué, la Présidente a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:
A) Que la présente Assemblée a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Décision de dissoudre anticipativement la société “LU-INVEST” et la mettre en liquidation;
2. Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs;
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4. Divers.
B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre de actions possédées par chacun d'eux, sont
portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux
représentés, les membres du bureau de l’Assemblée et le notaire instrumentant.
C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées “ne varietur” par les membres du bureau de l’Assemblée
et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.
D) Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés,
déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l’ordre du jour préalablement à cette Assemblée et
renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.
E) Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement sur les objets portés à l’ordre du jour.
Ensuite l’Assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée décide avec effet immédiat de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation volontaire.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide de nommer Monsieur Claude KLISSING, restaurateur, né à Metz (France), le 28 février 1958,
demeurant à F-57070 St. Julien-lès-Metz, 1, Allée du Fort (France), en tant que liquidateur (le “Liquidateur”) de la Société.
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée décide de conférer au Liquidateur les pouvoirs les plus étendus, prévus par les articles 144 et suivants
de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée (la “Loi”).
182035
L
U X E M B O U R G
L'Assemblée décide également d'instruire le Liquidateur, dans la limite de ses capacités et selon les circonstances, afin
qu'il réalise l’ensemble des actifs et solde les dettes de la Société.
L'Assemblée décide que le Liquidateur sera autorisé à signer tous actes et effectuer toutes opérations au nom de la
Société, y compris les actes et opérations stipulés dans l’article 145 de la Loi, sans autorisation préalable de l’assemblée
générale des actionnaires. Le Liquidateur pourra déléguer ses pouvoirs pour des opérations spécifiques ou d'autres tâches
à une ou plusieurs personnes ou entités, tout en conservant seul la responsabilité des opérations et tâches ainsi déléguées.
L'Assemblée décide également de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur, pour le compte de la Société en liqui-
dation, afin qu'il exécute, délivre, et effectue toutes obligations relatives à tout contrat ou document requis pour la
liquidation de la Société et à la liquidation de ses actifs.
L'Assemblée décide en outre de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur afin d'effectuer, à sa discrétion, tous
versements d'avances en numéraire ou en nature des boni de liquidation aux actionnaires de la Société, conformément
à l’article 148 de la Loi.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée décide d'accorder décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société pour
l’exercice de leurs mandats respectifs jusqu'à la date des présentes.
L’Assemblée décide de reconnaître, approuver, ratifier et reprendre au compte de la Société tous les actes pris par
les administrateurs de la Société pour la période débutant à la date de constitution de la Société et se terminant à ce jour
et de renoncer à son droit d’exercer tout recours à l’encontre des administrateurs résultant de leur gestion de la Société.
Aucun autre point n'étant porté à l’ordre du jour de l’Assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés
ne demandant la parole, le Président a ensuite clôturé l’Assemblée.
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à neuf cent cinq euros.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits
comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: V. PIERRU, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 28 octobre 2014. LAC/2014/50088. Reçu douze euros 12,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
Luxembourg, le 17 novembre 2014.
Référence de publication: 2014177775/78.
(140203843) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2014.
Capinera S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 129.675.
<i>Extrait de l'assemblée générale ordinaire des associés de la Société Capinera Sàrl qui s'est tenue à Luxembourg le 21 novembrei>
<i>2014 à 9.00 heures.i>
<i>Résolution unique:i>
L'assemblée générale décide de nommer pour une durée indéterminée Madame Francesca DOCCHIO née le 29 mai
1971 à Bergamo (I) résident professionnellement au 5, Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg nouveau gérant en
remplacement de Monsieur Marco STERZI.
Luxembourg, le 21 novembre 2014.
Pour copie conforme
<i>Pour Le Conseil de Gérance
i>Francesca Docchio
<i>Géranti>
Référence de publication: 2014184751/18.
(140208642) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2014.
182036
L
U X E M B O U R G
Diamar, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8399 Windhof, 22, rue de l'Industrie.
R.C.S. Luxembourg B 191.856.
STATUTS
L'an deux mille quatorze, le vingt-huit octobre
Par-devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg.
A COMPARU:
Mme Virginie PIERRU, employée, demeurant professionnellement au 12, rue Jean Engling L-1466 Luxembourg,
agissant en tant que mandataire de Madame Aldina de Fatima SILVA, responsable commercial, né le 29 août 1963 à
Marzagão (Carrazeda de Ansiâes) (Portugal), demeurant au 20, rue Schauwenburg, L-8092 Bertrange, en vertu d’une
procuration donnée sous seing privé en date du 13 octobre 2014.
Laquelle procuration, après avoir été paraphée «ne varietur», restera annexées au présent acte pour les besoins de
l’enregistrement.
Le comparant, représenté comme ci-avant, a prié le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une
société à responsabilité limitée à constituer.
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et
par les présents statuts.
Art. 2. La société prend la dénomination de DIAMAR.
Art. 3. La société a pour objet l’achat, la vente, la location et l’entretien de matériaux pour le secteur horeca, jeux
automatiques, boissons, ainsi que des produits y relatifs.
La société est autorisée à contracter des emprunts pour son propre compte et à accorder tous cautionnements ou
garanties.
Elle pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières
qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.
Art. 4. Le siège social est établi dans la Commune de Koerich.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision des associés.
Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu'à cessation complète des circonstances anormales. Une
telle décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège sera faite et portée à
la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.
Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales
de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés qu'avec l’agrément de tous les associés.
Art. 8. La société n'est pas dissoute par le décès, l’incapacité, la faillite ou la déconfiture d'un associé.
Art. 9. Les créanciers personnels, ayants droit ou héritiers d'un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit,
faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et à tout moment révocables
par l’assemblée des associés.
Chaque gérant est nommé pour une période indéterminée.
En cas de gérant unique, la société est engagée par la signature individuelle de celui-ci, et, en cas de pluralité de gérants,
par la signature conjointe de deux gérants.
Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire vala-
blement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une
société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de l’associé unique
182037
L
U X E M B O U R G
ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les assemblées
générales des associés ne sont pas applicables.
Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la société.
Art. 13. En cas de pluralité de gérants, les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance.
Tout gérant peut assister à une réunion du conseil de gérance s'il intervient par téléphone, vidéoconférence, ou tout
autre moyen de télécommunication approprié et permettant à toutes les personnes participant à la réunion de commu-
niquer à un même moment.
La participation à une réunion du conseil de gérance par de tels moyens est réputée équivalente à une participation
en personne.
Les résolutions écrites approuvées et signées par tous les gérants auront le même effet que les résolutions prises en
conseil de gérance.
Dans ce cas, les résolutions ou décisions doivent être expressément prises, soit formulées par écrit par voie circulaire,
par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de télécommuni-
cation approprié.
Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.
Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire com-
prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels pendant les quinze
jours qui précéderont son approbation.
Art. 18. L'excédent favorable du compte des profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales,
amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la société.
Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront prélevés et affectés à la réserve légale. Ces prélèvements
et affectations cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve aura atteint un dixième du capital social, mais devront être
repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se
trouve entamé. Le solde est à la libre disposition des associés.
Art. 19. Les gérants peuvent, à tout moment pendant l’année fiscale, décider de distribuer des dividendes intérimaires,
en se conformant aux dispositions légales.
Art. 20. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.
Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux
dispositions légales.
<i>Disposition transitoire:i>
Le premier exercice commencera aujourd'hui et se terminera le 31 décembre 2014.
<i>Souscription et libération:i>
Les cent (100) parts sociales ont été entièrement souscrites par la comparante Madame Aldina de Fatima SILVA,
prénommée et ici représentée comme ci-avant.
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées moyennant apport en numéraire, de sorte que le montant de
douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) est dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié
au notaire instrumentant qui le constate.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et changes, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué à environ neuf cents euros (900,- EUR).
<i>Décisions de l’associée unique:i>
Immédiatement après la constitution de la société, l’associée unique, représentée comme ci-avant et représentant
l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des gérants est fixé à un (1).
2.- Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée:
182038
L
U X E M B O U R G
Monsieur Joaõ Carlos PAIVA SANTOS, gérant de sociétés, né le 11 août 1963 à Figueira da Foz (Portugal), demeurant
au 20, rue Schauwenburg, L-8092 Bertrange.
3.- La société est engagée, en toutes circonstances, par la signature individuelle du gérant unique.
3.- L'adresse de la société est fixée à L-8399 Windhof, 22, rue de l’Industrie.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, connue du notaire par son nom,
prénoms usuels, état et demeure, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: V. PIERRU, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 4 novembre 2014. LAC/2014/51388. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.
Luxembourg, le 14 novembre 2014.
Référence de publication: 2014177510/117.
(140203669) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2014.
Lutrac Constructions Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5445 Schengen, 47, route du Vin.
R.C.S. Luxembourg B 87.244.
Pars Real Estate Foundation Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5445 Schengen, 47, route du Vin.
R.C.S. Luxembourg B 87.244.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
Par jugement(s) rendu(s) en date du 20 novembre 2014, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière commerciale, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société
ci-après indiquée, en mettant les frais à charge du Trésor:
la société à responsabilité limitée «LUTRAC CONSTRUCTIONS SARL» (anc. «PARS REAL ESTATE FOUNDATION
SARL»), immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B87.244, ayant eu son siège social
à L-5445 Schengen, 47, route du Vin;
POUR EXTRAIT CONFORME
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2014185046/16.
(140206402) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2014.
Highstreet AcquiCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 408.914,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 188.980.
In the year two thousand and fourteen, on the eleventh day of November.
Before Maître Edouard Delosch, notary residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
CORESTATE CAPITAL AG, a company incorporated under the laws of Switzerland, having its registered office at
Baarerstrasse 135, CH-6300 Zug (Switzerland), registered with the trade register of Kanton Zug under number
CH-113.002.233 (the “Sole Shareholder”),
hereby represented by Maître Patrick Chantrain, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on No-
vember 2014. The above mentioned proxy, signed by the appearing person and the undersigned notary, shall remain
annexed to the present deed.
The Sole Shareholder, represented as above mentioned, has requested the undersigned notary to record that the Sole
Shareholder is the sole shareholder of HIGHSTREET AcquiCo S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité
limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of fifty thousand Euro (EUR
50,000.-), whose registered office is at 35, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incor-
porated following a deed of the undersigned notary, of 25 July 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations number 2644 of 30 September 2014 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and
Companies under number B 188.980 (the “Company”). The articles of association of the Company have been amended
182039
L
U X E M B O U R G
for the last time following a deed of Maître Francis Kessler, notary residing in Esch-sur-Alzette, acting in replacement of
the undersigned notary of 8 August 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2828
of 9 October 2014.
The Sole Shareholder, represented as above mentioned, has recognised to be duly and fully informed of the resolutions
to be taken on the basis of the following agenda:
<i>Agendai>
1. To increase the corporate capital of the Company by an amount of EUR 358,914.- (three hundred fifty-eight thousand
nine hundred fourteen Euro) so as to raise it from its present amount of EUR 50,000.- (fifty thousand Euro) to EUR
408,914.- (four hundred eight thousand nine hundred fourteen Euro).
2. To issue 358,914 (three hundred fifty-eight thousand nine hundred fourteen) new shares, having a par value of EUR
1.- (one Euro) each as well as the rights and privileges as those set out in the Company's articles of association.
3. To accept the subscription of the newly issued 358,914 (three hundred fifty-eight thousand nine hundred fourteen)
shares in consideration for a contribution in cash.
4. To set the amount of the Company's share capital at EUR 408,914.- (four hundred eight thousand nine hundred
fourteen Euro) represented by 408,914 (four hundred eight thousand nine hundred fourteen) shares having a par value
of EUR 1.- (one Euro) each.
5. To amend articles five (5), seven (7), nine (9), twelve (12) and fifteen (15) of the Company's articles of association.
6. Miscellaneous.
The Sole Shareholder, represented as above mentioned, has requested the undersigned notary to record the following
resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to increase the corporate capital of the Company by an amount of EUR 358,914.-
(three hundred fifty-eight thousand nine hundred fourteen Euro) so as to raise it from its present amount of EUR 50,000.-
(fifty thousand Euro) to EUR 408,914.- (four hundred eight thousand nine hundred fourteen Euro).
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to issue 358,914 (three hundred fifty-eight thousand nine hundred fourteen) new shares,
each share having a par value of EUR 1.- (one Euro) as well as the rights and privileges as those set out in the Company's
articles of association.
<i>Subscription - Paymenti>
1. Thereupon appeared SO HOLDING AG, a company incorporated under the laws of Switzerland, having its regis-
tered office at Poststrasse 4, CH-8808 Pfäffikon (Switzerland) and registered with the trade register of Kanton Schwyz
under number CH-130.3.009.720-8 (hereafter “SO”), represented by Mr Patrick Chantrain, by virtue of a proxy given on
November 2014, which proxy, signed by the proxyholder and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed to be filed at the same time with the registration authorities.
SO declared to subscribe for 116,279 (one hundred sixteen thousand two hundred seventy-nine) new shares, each
share having a par value of EUR 1.- (one Euro) and to fully pay in cash for these new shares.
The aggregate amount of EUR 116,279.- (one hundred sixteen thousand two hundred seventy-nine Euro) was thus as
from that moment at the disposal of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.
2. Thereupon appeared KERALA INTERNATIONAL Inc., a company incorporated under the laws of Panama, having
its registered office at Calle Aquilino de la Guardia No. 8, IGRA Building, PO Box 0823-02435, Panama, Panama and
registered with the Register of Commerce of Panama under number 757048 (hereafter “Kerala”), represented by Mr
Patrick Chantrain, by virtue of a proxy given on November 2014, which proxy, signed by the proxyholder and the
undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Kerala declared to subscribe for 1,550 (one thousand five hundred fifty) new shares, each share having a par value of
EUR 1.- (one Euro) and to fully pay in cash for these new shares.
The aggregate amount of EUR 1,550.- (one thousand five hundred fifty Euro) was thus as from that moment at the
disposal of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.
3. Thereupon appeared CORESTATE MCIF GmbH & Co. KG, a company incorporated under the laws of Germany,
having its registered office at c/o HauckSchuchardt, Niedenau 61-63, 60235 Frankfurt am Main, Germany and registered
with the Register of Commerce A of the District Court of Frankfurt am Main under number HRA 46691 (hereafter
“CORESTATE MCIF”), represented by Mr Patrick Chantrain, by virtue of a proxy given on November 2014, which proxy,
signed by the proxyholder and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.
CORESTATE MCIF declared to subscribe for 1,550 (one thousand five hundred fifty) new shares, each share having a
par value of EUR 1.- (one Euro) and to fully pay in cash for these new shares.
182040
L
U X E M B O U R G
The aggregate amount of EUR 1,550.- (one thousand five hundred fifty Euro) was thus as from that moment at the
disposal of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.
4. Thereupon appeared ADEL INVESTMENT Limited, a company incorporated under the laws of Negara Brunei
Darussalam, having its registered office at 41, Cator Road, Britannia House, 4
th
Floor, Bandar Seri Begawan BS 8811,
Negara Brunei Darussalam and registered with the registrar of companies of Negara Brunei Darussalam under number
NBD/11642 (hereafter “Adel”), represented by Mr Patrick Chantrain, by virtue of a proxy given on November 2014,
which proxy, signed by the proxyholder and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed
at the same time with the registration authorities.
Adel declared to subscribe for 15,504 (fifteen thousand five hundred four) new shares, each share having a par value
of EUR 1.- (one Euro) and to fully pay in cash for these new shares.
The aggregate amount of EUR 15,504.- (fifteen thousand five hundred four Euro) was thus as from that moment at the
disposal of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.
5. Thereupon appeared vitB AG, a company incorporated under the laws of Switzerland, having its registered office
at Baarerstrasse 135, 6300 Zug, Switzerland and registered with the trade register of Kanton Zug under number
CH-170.3.033.667-4 (hereafter “vitB”), represented by Mr Patrick Chantrain, by virtue of a proxy given on November
2014, which proxy, signed by the proxyholder and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to
be filed at the same time with the registration authorities.
vitB declared to subscribe for 46,512 (forty-six thousand five hundred twelve) new shares, each share having a par
value of EUR 1.- (one Euro) and to fully pay in cash for these new shares.
The aggregate amount of EUR 46,512.- (forty-six thousand five hundred twelve Euro) was thus as from that moment
at the disposal of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.
6. Thereupon appeared BRAVOD Ltd, a company incorporated under the laws of Anguilla, having its registered office
at The Mason Complex, Suites 19 & 20, The Valley, Anguilla, British West Indies and registered with the Register of
Commerce of Anguilla under number 2235607 (hereafter “Bravod”), represented by Mr Patrick Chantrain, by virtue of
a proxy given on November 2014, which proxy, signed by the proxyholder and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Bravod declared to subscribe for 1,550 (one thousand five hundred fifty) new shares, each share having a par value of
EUR 1.- (one Euro) and to fully pay in cash for these new shares.
The aggregate amount of EUR 1,550.- (one thousand five hundred fifty Euro) was thus as from that moment at the
disposal of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.
7. Thereupon appeared Atlant High Street S.à r.l., a company incorporated under the laws of the Grand-Duchy of
Luxembourg, having its registered office at 6, rue Guillaume Schneider, 2522, Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg
and not yet registered with the Luxembourg register of commerce and companies (hereafter “Atlant”), represented by
Mr Patrick Chantrain, by virtue of a proxy given on November 2014, which proxy, signed by the proxyholder and the
undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Atlant declared to subscribe for 38,760 (thirty-eight thousand seven hundred sixty) new shares, each share having a
par value of EUR 1.- (one Euro) and to fully pay in cash for these new shares.
The aggregate amount of EUR 38,760.- (thirty-eight thousand seven hundred sixty Euro) was thus as from that moment
at the disposal of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.
8. Thereupon appeared CHINAWHITE S.A., a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands,
having its registered office at Akara Bldg., 24 de Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin
Islands and registered with the Registrar of Corporate Affairs under number 1657007 (hereafter “Chinawhite”), repre-
sented by Mr Patrick Chantrain, by virtue of a proxy given on November 2014, which proxy, signed by the proxyholder
and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.
Chinawhite declared to subscribe for 38,760 (thirty-eight thousand seven hundred sixty) new shares, each share having
a par value of EUR 1.- (one Euro) and to fully pay in cash for these new shares.
The aggregate amount of EUR 38,760.- (thirty-eight thousand seven hundred sixty Euro) was thus as from that moment
at the disposal of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.
9. Thereupon appeared Cara Trading Ltd, a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands, having
its registered office at Palm Grove House, P.O. Box 438, Road Town, Tortola, British Virgin Islands and registered with
the Registrar of Corporate Affairs under number 1521956 (hereafter “Cara Trading”), represented by Mr Patrick Chan-
train, by virtue of a proxy given on November 2014, which proxy, signed by the proxyholder and the undersigned notary,
will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Cara Trading declared to subscribe for 3,876 (three thousand eight hundred seventy-six) new shares, each share having
a par value of EUR 1.- (one Euro) and to fully pay in cash for these new shares.
The aggregate amount of EUR 3,876.- (three thousand eight hundred seventy-six Euro) was thus as from that moment
at the disposal of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.
182041
L
U X E M B O U R G
10. Thereupon appeared CKU AG, a company incorporated under the laws of Switzerland, having its registered office
at 156, Zürcherstrasse, 8645 Jona-Rapperswil, Switzerland and registered with the trade register of Kanton St. Gallen
under number CH-320.3.002.460-6 (hereafter “CKU”), represented by Mr Patrick Chantrain, by virtue of a proxy given
on November 2014, which proxy, signed by the proxyholder and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
CKU declared to subscribe for 31,008 (thirty-one thousand and eight) new shares, each share having a par value of
EUR 1.- (one Euro) and to fully pay in cash for these new shares.
The aggregate amount of EUR 31,008.- (thirty-one thousand and eight Euro) was thus as from that moment at the
disposal of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.
11. Thereupon appeared Cavalier Capital Corporation, a company incorporated under the laws of Panama, having its
registered office at East 54
th
Street, Arango-Orillac Building, 2
nd
Floor, PA-Panama, Panama and registered with the
Register of Commerce of Panama under number 538873 (hereafter “Cavalier”), represented by Mr Patrick Chantrain,
by virtue of a proxy given on November 2014, which proxy, signed by the proxyholder and the undersigned notary, will
remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Cavalier declared to subscribe for 7,752 (seven thousand seven hundred fifty-two) new shares, each share having a
par value of EUR 1.- (one Euro) and to fully pay in cash for these new shares.
The aggregate amount of EUR 7,752.- (seven thousand seven hundred fifty-two Euro) was thus as from that moment
at the disposal of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.
12. Thereupon appeared Cupstone Ltd., a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands, having
its registered office at Nerine Chambers, P.O. Box 905, Road Town, Tortola, British Virgin Islands and registered with
the Registrar of Corporate Affairs under number 1048031 (hereafter “Cupstone”), represented by Mr Patrick Chantrain,
by virtue of a proxy given on November 2014, which proxy, signed by the proxyholder and the undersigned notary, will
remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Cupstone declared to subscribe for 15,504 (fifteen thousand five hundred four) new shares, each share having a par
value of EUR 1.- (one Euro) and to fully pay in cash for these new shares.
The aggregate amount of EUR 15,504.- (fifteen thousand five hundred four Euro) was thus as from that moment at the
disposal of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.
13. Thereupon appeared Future Definite Holdings Limited, a company incorporated under the laws of the British Virgin
Islands, having its registered office at Yamraj Building, P.O. Box 875, Road Town, Tortola, British Virgin Islands and
registered with the Registrar of Corporate Affairs under number 1794687 (hereafter “Future Definite Holdings”), re-
presented by Mr Patrick Chantrain, by virtue of a proxy given on November 2014, which proxy, signed by the proxyholder
and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.
Future Definite Holdings declared to subscribe for 11,628 (eleven thousand six hundred twenty-eight) new shares,
each share having a par value of EUR 1.- (one Euro) and to fully pay in cash for these new shares.
The aggregate amount of EUR 11,628.- (eleven thousand six hundred twenty-eight Euro) was thus as from that moment
at the disposal of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.
14. Thereupon appeared Voit Foundation, a foundation incorporated under the laws of Liechtenstein, having its re-
gistered office at Felbaweg 10, FL-9494 Schaan, Liechtenstein and registered with the Öffentlichkeitsregister Liechtenstein
under number FL-0002.298.950-7 (hereafter “Voit”), represented by Mr Patrick Chantrain, by virtue of a proxy given on
November 2014, which proxy, signed by the proxyholder and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Voit declared to subscribe for 7,752 (seven thousand seven hundred fifty-two) new shares, each share having a par
value of EUR 1.- (one Euro) and to fully pay in cash for these new shares.
The aggregate amount of EUR 7,752.- (seven thousand seven hundred fifty-two Euro) was thus as from that moment
at the disposal of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.
15. Thereupon appeared ARMIGER INVESTMENT Inc., a company incorporated under the laws of the British Virgin
Islands, having its registered office at Trinity Chambers, P.O. Box 4301, Road Town, Tortola, British Virgin Islands and
registered with the Registrar of Corporate Affairs under number 1501659 (hereafter “Armiger”), represented by Mr
Patrick Chantrain, by virtue of a proxy given on November 2014, which proxy, signed by the proxyholder and the
undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Armiger declared to subscribe for 5,426 (five thousand four hundred twenty-six) new shares, each share having a par
value of EUR 1.- (one Euro) and to fully pay in cash for these new shares.
The aggregate amount of EUR 5,426.- (five thousand four hundred twenty-six Euro) was thus as from that moment at
the disposal of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.
16. Thereupon appeared Mr. Jürg MARQUARD, born on the 13 July 1945, residing at Villa Bella Vista, Biswindstrasse
17, 8704 Herrliberg, Switzerland (hereafter “Mr. Marquard”), represented by Mr Patrick Chantrain, by virtue of a proxy
given on November 2014, which proxy, signed by the proxyholder and the undersigned notary, will remain annexed to
the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
182042
L
U X E M B O U R G
Mr. Marquard declared to subscribe for 7,364 (seven thousand three hundred sixty-four) new shares, each share having
a par value of EUR 1.- (one Euro) and to fully pay in cash for these new shares.
The aggregate amount of EUR 7,364.- (seven thousand three hundred sixty-four Euro) was thus as from that moment
at the disposal of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.
17. Thereupon appeared BLACK DOG HOLDINGS Ltd., a company incorporated under the laws of the Seychelles,
having its registered office at Suite 15, 1
st
Floor Oliaji Trade Centre, Francis Rachel Street, P.O. Box 1004, Victoria,
Mahé, Seychelles and registered with the Registrar of International Business Companies under number 136725 (hereafter
“Black Dog”), represented by Mr Patrick Chantrain, by virtue of a proxy given on November 2014, which proxy, signed
by the proxyholder and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time
with the registration authorities.
Black Dog declared to subscribe for 1,938 (one thousand nine hundred thirty-eight) new shares, each share having a
par value of EUR 1.- (one Euro) and to fully pay in cash for these new shares.
The aggregate amount of EUR 1,938.- (one thousand nine hundred thirty-eight Euro) was thus as from that moment
at the disposal of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.
18. Thereupon appeared GULF POINT Ltd., a company incorporated under the laws of the Marshall Islands, having
its registered office at Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands MH96960 and
registered with the Office of the Registrar of Corporations under number 44482 (hereafter “Gulf”), represented by Mr
Patrick Chantrain, by virtue of a proxy given on November 2014, which proxy, signed by the proxyholder and the
undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Gulf declared to subscribe for 2,713 (two thousand seven hundred thirteen) new shares, each share having a par value
of EUR 1.- (one Euro) and to fully pay in cash for these new shares.
The aggregate amount of EUR 2,713.- (two thousand seven hundred thirteen Euro) was thus as from that moment at
the disposal of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.
19. Thereupon appeared Mr. Thomas BORER, born on the 29 July 1957 in Basel (Switzerland), residing at c/o Borer
Consulting, Seestrasse 83, 8800 Thalwil, Zurich, Switzerland (hereafter “Mr. Borer”), represented by Mr Patrick Chan-
train, by virtue of a proxy given on November 2014, which proxy, signed by the proxyholder and the undersigned notary,
will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Mr. Borer declared to subscribe for 1,938 (one thousand nine hundred thirty-eight) new shares, each share having a
par value of EUR 1.- (one Euro) and to fully pay in cash for these new shares.
The aggregate amount of EUR 1,938.- (one thousand nine hundred thirty-eight Euro) was thus as from that moment
at the disposal of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.
20. Thereupon appeared Mr. Rolf FURRER, born on the 24 April 1962, residing at Schlapprig 2A, 8847 Egg, Switzerland
(hereafter “Mr. Furrer”), represented by Mr Patrick Chantrain, by virtue of a proxy given on November 2014, which
proxy, signed by the proxyholder and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the
same time with the registration authorities.
Mr. Furrer declared to subscribe for 1,550 (one thousand five hundred fifty) new shares, each share having a par value
of EUR 1.- (one Euro) and to fully pay in cash for these new shares.
The aggregate amount of EUR 1,550.- (one thousand five hundred fifty Euro) was thus as from that moment at the
disposal of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.
Further to the aforementioned subscriptions, a total amount of EUR 358,914.- (three hundred fifty-eight thousand
nine hundred fourteen Euro) was thus as from that moment at the disposal of the Company, evidence thereof having
been submitted to the undersigned notary.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to accept said subscriptions and payments and to allot the 358,914 (three hundred
fifty-eight thousand nine hundred fourteen) new shares as fully paid in shares to the above mentioned subscribers.
<i>Fourth resolutioni>
The general meeting of shareholders resolved to set the amount of the corporate capital of the Company at EUR
408,914.- (four hundred eight thousand nine hundred fourteen Euro) represented by 408,914 (four hundred eight thou-
sand nine hundred fourteen) shares, each share having a par value of EUR 1.- (one Euro) as well as the rights and privileges
as those set out in the Company's articles of association.
<i>Fifth resolutioni>
The general meeting of shareholders resolved to amend articles five (5), seven (7), nine (9), twelve (12) and fifteen
(15) of the Company's articles of association, which shall forthwith read as follows:
Article five (5) of the Company's articles of association shall henceforth read as follows:
182043
L
U X E M B O U R G
“ Art. 5. Share capital. The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 408,914.- (four hundred eight thousand
nine hundred fourteen Euro), represented by 408,914 (four hundred eight thousand nine hundred fourteen) shares, each
share having a par value of EUR 1.- (one Euro).”
Article seven (7) of the Company's articles of association shall forthwith read as follows:
“ Art. 7. Profit sharing. Save as otherwise provided for in (i) these articles of association and (ii) any shareholders'
agreement or, as the case may be, any other similar agreement that may be entered into from time to time by the
shareholders, each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion
to the number of shares in existence.”
Article nine (9) of the Company's articles of association shall forthwith read as follows:
“ Art. 9. Transfer of shares. In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely
transferable.
In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorized by the general
meeting of the shareholders who represent at least three-quarters of the paid-in capital of the Company. No such au-
thorization is required for a transfer of shares among the shareholders.
The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-
quarters of the rights belonging to the surviving shareholders.
Any transfer of shares is subject to the provisions of this article 9, to articles 189 and 190 of the Luxembourg act dated
10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Companies Act) as well as to any restriction provided for
in a shareholders' agreement or, as the case may be, any other similar agreement that may be entered into from time to
time by the shareholders.”
Paragraph four (4) of article twelve (12) of the Company's articles of association shall forthwith read as follows:
“ Art. 12. Management. Paragraph four (4). All powers not expressly reserved by law, the present articles of association
or any shareholders' agreement or, as the case may be, any other similar agreement that may be entered into from time
to time by the shareholders, to the general meeting of the shareholders fall within the power of the manager, or in case
of plurality of managers, of the board of managers.”
Article fifteen (15) of the Company's articles of association shall forthwith read as follows:
“ Art. 15. Shareholders' voting rights, quorum and majority. The sole shareholder assumes all powers conferred to
the general meeting of the shareholders.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number
of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding.
The majority requirements for decisions taken by the shareholders are determined by the Companies Act and by any
shareholders' agreement or, as the case may be, any other similar agreement that may be entered into from time to time
by the shareholders.”
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed, are estimated at approximately EUR 1,800.- (one thousand eight hundred Euro).
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a German version; at the request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and German texts, the English version shall prevail.
The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by its surname, first name,
civil status and residence, the said persons signed together with the notary this original deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:
Im Jahre zweitausendvierzehn, am elften Tag des Monats November.
vor Maître Edouard Delosch, Notar mit Amtssitz in Diekirch, Großherzogtum Luxemburg,
IST ERSCHIENEN,
CORESTATE CAPITAL AG, eine Gesellschaft Schweizer Rechts mit Gesellschaftssitz in Baarerstrasse 135, CH-6300
Zug (Schweiz), eingetragen im Handelsregister des Kantons Zug unter der Nummer CH-113.002.233, (die „Alleingesell-
schafterin“),
hier vertreten durch Maître Patrick Chantrain, mit Berufsanschrift in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht unter
Privatschrift, ausgestellt am November 2014.
Vorbezeichnete Vollmacht wird nach Unterzeichnung ne varietur durch die erschienene Person und den Notar dieser
Urkunde als Anlage beigefügt bleiben.
182044
L
U X E M B O U R G
Die Alleingesellschafterin, wie vorstehend vertreten, hat den amtierenden Notar gebeten, zu beurkunden, dass die
Alleingesellschafterin die alleinige Gesellschafterin der HIGHSTREET AcquiCo S.à r.l. ist, eine Gesellschaft mit beschränk-
ter Haftung (société à responsabilité limitée) unterliegend dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit einem
Gesellschaftskapital in Höhe von fünfzigtausend Euro (EUR 50.000,-), mit Gesellschaftssitz in 35, avenue Monterey, L-2163
Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, gegründet gemäß Urkunde erstellt durch den unterzeichneten Notar, vom 25.
Juli 2014, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 2644 vom 30. September 2014,
und eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 188.980 (die „Gesellschaft“).
Die Satzung der Gesellschaft wurde zum letzten Mal geändert gemäß Urkunde aufgenommen durch Maître Francis Kessler,
Notar mit Amtssitz in Esch-sur-Alzette, in Vertretung des unterzeichneten Notars vom 8. August 2014, veröffentlicht im
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 2828 vom 9. Oktober 2014.
Die Alleingesellschafterin, wie vorstehend vertreten, erkennt ausdrücklich an, von den aufgrund der folgenden Tages-
ordnung zu fassenden Beschlüssen umfassende Kenntnis gehabt zu haben:
<i>Tagesordnungi>
1. Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft um einen Betrag in Höhe von EUR 358.914,- (dreihundertach-
tundfünfzigtausendneunhundertvierzehn Euro), um dieses von seinem derzeitigen Betrag in Höhe von EUR 50.000
(fünfzigtausend Euro) auf EUR 408.914,- (vierhundertachttausendneunhundertvierzehn Euro) zu bringen.
2. Schaffung von 358.914 (dreihundertachtundfünfzigtausendneunhundertvierzehn) neuen Anteilen mit einem Nenn-
wert von je EUR 1,- (ein Euro), die die gleichen Rechte und Privilegien haben, wie in der Satzung der Gesellschaft
beschrieben.
3. Annahme der Zeichnung der neu geschaffenen 358.914 (dreihundertachtundfünfzigtausendneunhundertvierzehn)
Anteile gegen Bareinlage.
4. Festsetzen des Kapitals der Gesellschaft auf EUR 408.914,- (vierhundertachttausendneunhundertvierzehn Euro)
eingeteilt in 408.914 (vierhundertachttausendneunhundertvierzehn) Anteile mit einem Nennwert von je EUR 1,- (ein
Euro).
5. Abänderung der Artikel fünf (5), sieben (7), neun (9), zwölf (12) und fünfzehn (15) der Satzung der Gesellschaft.
6. Verschiedenes.
Die Alleingesellschafterin hat den amtierenden Notar gebeten, folgende Beschlussfassungen aufzunehmen:
<i>Erster Beschlussi>
Die Alleingesellschafterin hat beschlossen, das Kapital der Gesellschaft um einen Betrag in Höhe von EUR 358.914,-
(dreihundertachtundfünfzigtausendneunhundertvierzehn Euro) zu erhöhen, um dieses von seinem derzeitigen Betrag in
Höhe von EUR 50.000.- (fünfzigtausend Euro) auf EUR 408.914,- (vierhundertachttausendneunhundertvierzehn Euro) zu
bringen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Alleingesellschafterin hat beschlossen, 358.914 (dreihundertachtundfünfzigtausendneunhundertvierzehn) neue An-
teile mit einem Nennwert von je EUR 1,- (ein Euro) und mit den gleichen Rechten und Privilegien, wie in der Satzung der
Gesellschaft beschrieben, zu schaffen.
<i>Zeichnung - Einzahlungi>
1. Daraufhin erschien SO HOLDING AG, eine Gesellschaft Schweizer Rechts, mit Gesellschaftssitz in Poststrasse 4,
CH-8808 Pfäffikon (Switzerland) und eingetragen beim Handelsregister des Kantons Schwyz unter der Nummer
CH-130.3.009.720-8 (nachstehend „SO”), vertreten durch Herrn Patrick Chantrain, aufgrund einer privatschriftlichen
Vollmacht erstellt am 10. November 2014, welche durch den Bevollmächtigten und den amtierenden Notar unterzeichnet
und dieser Urkunde beiliegen bleibt und zusammen mit ihr zur Registrierung eingereicht werden wird.
SO gab an 116.279 (einhundertsechzehntausendzweihundertneunundsiebzig) neue Anteile mit einem Nennwert von
je EUR 1,- (ein Euro) zu zeichnen und diese neuen Anteile mittels Bareinlage voll einzuzahlen.
Der Gesamtbetrag in Höhe von EUR 116.279,- (einhundertsechzehntausendzweihundertneunundsiebzig Euro) stand
fortan der Gesellschaft zur Verfügung. Ein Beweis hierfür wurde dem amtierenden Notar vorgelegt.
2. Daraufhin erschien KERALA INTERNATIONAL Inc., eine Gesellschaft unterliegend dem Recht Panamas, mit Ge-
sellschaftssitz in Calle Aquilino de la Guardia No. 8, IGRA Building, PO Box 0823-02435, Panama, Panama und eingetragen
im Handelsregister von Panama unter der Nummer 757048 (nachstehend „Kerala”), vertreten durch Herrn Patrick
Chantrain, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht erstellt am 10. November 2014, welche durch den Bevollmäch-
tigten und den amtierenden Notar unterzeichnet und dieser Urkunde beiliegen bleibt und zusammen mit ihr zur
Registrierung eingereicht werden wird.
Kerala gab an 1.550 (eintausendfünfhundertfünfzig) neue Anteile mit einem Nennwert von je EUR 1,- (ein Euro) zu
zeichnen und diese neuen Anteile mittels Bareinlage voll einzuzahlen.
Der Gesamtbetrag in Höhe von EUR 1.550,- (eintausendfünfhundertfünfzig Euro) stand fortan der Gesellschaft zur
Verfügung. Ein Beweis hierfür wurde dem amtierenden Notar vorgelegt.
182045
L
U X E M B O U R G
3. Daraufhin erschien CORESTATE MCIF GmbH & Co. KG, eine Gesellschaft deutschen Rechts, mit Gesellschaftssitz
in c/o HauckSchuchardt, Niedenau 61-63, 60235 Frankfurt am Main, Deutschland und eingetragen beim Handelsregister
A des Bezirksgerichts Frankfurt am Main unter der Nummer HRA 46691 (nachstehend „CORESTATE MCIF”), vertreten
durch Herrn Patrick Chantrain, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht erstellt am 10. November 2014, welche durch
den Bevollmächtigten und den amtierenden Notar unterzeichnet und dieser Urkunde beiliegen bleibt und zusammen mit
ihr zur Registrierung eingereicht werden wird.
CORESTATE MCIF gab an 1.550 (eintausendfünfhundertfünfzig) neue Anteile mit einem Nennwert von je EUR 1,- (ein
Euro) zu zeichnen und diese neuen Anteile mittels Bareinlage voll einzuzahlen.
Der Gesamtbetrag in Höhe von EUR 1.550,- (eintausendfünfhundertfünfzig Euro) stand fortan der Gesellschaft zur
Verfügung. Ein Beweis hierfür wurde dem amtierenden Notar vorgelegt.
4. Daraufhin erschien ADEL INVESTMENT Limited, eine Gesellschaft unterliegend dem Recht von Negara Brunei
Darussalam, mit Gesellschaftssitz in 41, Cator Road, Britannia House, 4
th
Floor, Bandar Seri Begawan BS 8811, Negara
Brunei Darussalam und eingetragen im Handelsregister Negara Brunei Darussalam unter der Nummer NBD/11642
(nachstehend „Adel”), vertreten durch Herrn Patrick Chantrain, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht erstellt am
10. November 2014, welche durch den Bevollmächtigten und den amtierenden Notar unterzeichnet und dieser Urkunde
beiliegen bleibt und zusammen mit ihr zur Registrierung eingereicht werden wird.
Adel gab an 15.504 (fünfzehntausendfünfhundertvier) neue Anteile mit einem Nennwert von je EUR 1,- (ein Euro) zu
zeichnen und diese neuen Anteile mittels Bareinlage voll einzuzahlen.
Der Gesamtbetrag in Höhe von EUR 15.504,- (fünfzehntausendfünfhundertvier Euro) stand fortan der Gesellschaft zur
Verfügung. Ein Beweis hierfür wurde dem amtierenden Notar vorgelegt.
5. Daraufhin erschien vitB AG, eine Gesellschaft Schweizer Rechts, mit Gesellschaftssitz in Baarerstrasse 135, 6300
Zug, Schweiz und eingetragen im Handelsregister des Kantons Zug unter der Nummer CH-170.3.033.667-4 (nachstehend
„vitB”), vertreten durch Herrn Patrick Chantrain, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht erstellt am 10. November
2014, welche durch den Bevollmächtigten und den amtierenden Notar unterzeichnet und dieser Urkunde beiliegen bleibt
und zusammen mit ihr zur Registrierung eingereicht werden wird.
vitB gab an 46.512 (sechsundvierzigtausendfünfhundertzwölf) neue Anteile mit einem Nennwert von je EUR 1,- (ein
Euro) zu zeichnen und diese neuen Anteile mittels Bareinlage voll einzuzahlen.
Der Gesamtbetrag in Höhe von EUR 46.512,- (sechsundvierzigtausendfünfhundertzwölf Euro) stand fortan der Ge-
sellschaft zur Verfügung. Ein Beweis hierfür wurde dem amtierenden Notar vorgelegt.
6. Daraufhin erschien BRAVOD Ltd, eine Gesellschaft unterliegend dem Recht Anguillas, mit Gesellschaftssitz in The
Mason Complex, Suites 19 & 20, The Valley, Anguilla, British West Indies und eingetragen im Handelsregister von Anguilla
unter der Nummer 2235607 (nachstehend „Bravod”), vertreten durch Herrn Patrick Chantrain, aufgrund einer privat-
schriftlichen Vollmacht erstellt am 10. November 2014, welche durch den Bevollmächtigten und den amtierenden Notar
unterzeichnet und dieser Urkunde beiliegen bleibt und zusammen mit ihr zur Registrierung eingereicht werden wird.
Bravod gab an 1.550 (eintausendfünfhundertfünfzig) neue Anteile mit einem Nennwert von je EUR 1,- (ein Euro) zu
zeichnen und diese neuen Anteile mittels Bareinlage voll einzuzahlen.
Der Gesamtbetrag in Höhe von EUR 1.550,- (eintausendfünfhundertfünfzig Euro) stand fortan der Gesellschaft zur
Verfügung. Ein Beweis hierfür wurde dem amtierenden Notar vorgelegt.
7. Daraufhin erschien Atlant High Street S.à r.l., eine Gesellschaft unterliegend dem Recht des Großherzogtums Lu-
xemburg, mit Gesellschaftssitz in 6, rue Guillaume Schneider, 2522, Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg und noch
nicht im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister eingetragen (nachstehend „Atlant”), vertreten durch Herrn
Patrick Chantrain, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht erstellt am. November 2014, welche durch den Bevoll-
mächtigten und den amtierenden Notar unterzeichnet und dieser Urkunde beiliegen bleibt und zusammen mit ihr zur
Registrierung eingereicht werden wird.
Atlant gab an 38.760 (achtunddreissigtausendsiebenhundertsechzig) neue Anteile mit einem Nennwert von je EUR 1,-
(ein Euro) zu zeichnen und diese neuen Anteile mittels Bareinlage voll einzuzahlen.
Der Gesamtbetrag in Höhe von EUR 38.760,- (achtunddreissigtausendsiebenhundertsechzig Euro) stand fortan der
Gesellschaft zur Verfügung. Ein Beweis hierfür wurde dem amtierenden Notar vorgelegt.
8. Daraufhin erschien CHINAWHITE S.A., eine Gesellschaft unterliegend dem Recht der Britischen Jungferninseln, mit
Gesellschaftssitz in Akara Bldg., 24 de Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands und
eingetragen im Registrar of Corporate Affairs unter der Nummer 1657007 (nachstehend „Chinawhite”), vertreten durch
Herrn Patrick Chantrain, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht erstellt am 10. November 2014, welche durch den
Bevollmächtigten und den amtierenden Notar unterzeichnet und dieser Urkunde beiliegen bleibt und zusammen mit ihr
zur Registrierung eingereicht werden wird.
Chinawhite gab an 38.760 (achtunddreissigtausendsiebenhundertsechzig) neue Anteile mit einem Nennwert von je
EUR 1,- (ein Euro) zu zeichnen und diese neuen Anteile mittels Bareinlage voll einzuzahlen.
Der Gesamtbetrag in Höhe von EUR 38.760,- (achtunddreissigtausendsiebenhundertsechzig Euro) stand fortan der
Gesellschaft zur Verfügung. Ein Beweis hierfür wurde dem amtierenden Notar vorgelegt.
182046
L
U X E M B O U R G
9. Daraufhin erschien Cara Trading Ltd, eine Gesellschaft unterliegend dem Recht der Britischen Jungferninseln, mit
Gesellschaftssitz in Palm Grove House, P.O. Box 438, Road Town, Tortola, British Virgin Islands und eingetragen im
Registrar of Corporate Affairs unter der Nummer 1521956 (nachstehend „Cara Trading”), vertreten durch Herrn Patrick
Chantrain, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht erstellt am 11. November 2014, welche durch den Bevollmäch-
tigten und den amtierenden Notar unterzeichnet und dieser Urkunde beiliegen bleibt und zusammen mit ihr zur
Registrierung eingereicht werden wird.
Cara Trading gab an 3.876 (dreitausendachthundertsechsundsiebzig) neue Anteile mit einem Nennwert von je EUR
1,- (ein Euro) zu zeichnen und diese neuen Anteile mittels Bareinlage voll einzuzahlen.
Der Gesamtbetrag in Höhe von EUR 3.876,- (dreitausendachthundertsechsundsiebzig Euro) stand fortan der Gesell-
schaft zur Verfügung. Ein Beweis hierfür wurde dem amtierenden Notar vorgelegt.
10. Daraufhin erschien CKU AG, eine Gesellschaft Schweizer Rechts, mit Gesellschaftssitz in 156, Zürcherstrasse,
8645 Jona-Rapperswil, Schweiz und eingetragen im Handelsregister des Kantons St. Gallen unter der Nummer
CH-320.3.002.460-6 (nachstehend „CKU”), vertreten durch Herrn Patrick Chantrain, aufgrund einer privatschriftlichen
Vollmacht erstellt am 10. November 2014, welche durch den Bevollmächtigten und den amtierenden Notar unterzeichnet
und dieser Urkunde beiliegen bleibt und zusammen mit ihr zur Registrierung eingereicht werden wird.
CKU gab an 31.008 (einunddreissigtausendundacht) neue Anteile mit einem Nennwert von je EUR 1,- (ein Euro) zu
zeichnen und diese neuen Anteile mittels Bareinlage voll einzuzahlen.
Der Gesamtbetrag in Höhe von EUR 31.008,- (einunddreissigtausendundacht Euro) stand fortan der Gesellschaft zur
Verfügung. Ein Beweis hierfür wurde dem amtierenden Notar vorgelegt.
11. Daraufhin erschien Cavalier Capital Corporation, eine Gesellschaft unterliegend dem Recht Panamas, mit Gesell-
schaftssitz in East 54
th
Street, Arango-Orillac Building, 2
nd
Floor, PA-Panama, Panama und eingetragen im Handelsregister
von Panama unter der Nummer 538873 (nachstehend „Cavalier”), vertreten durch Herrn Patrick Chantrain, aufgrund
einer privatschriftlichen Vollmacht erstellt am. November 2014, welche durch den Bevollmächtigten und den amtierenden
Notar unterzeichnet und dieser Urkunde beiliegen bleibt und zusammen mit ihr zur Registrierung eingereicht werden
wird.
Cavalier gab an 7.752 (siebentausendsiebenhundertzweiundfünfzig) neue Anteile mit einem Nennwert von je EUR 1,-
(ein Euro) zu zeichnen und diese neuen Anteile mittels Bareinlage voll einzuzahlen.
Der Gesamtbetrag in Höhe von EUR 7.752,- (siebentausendsiebenhundertzweiundfünfzig Euro) stand fortan der Ge-
sellschaft zur Verfügung. Ein Beweis hierfür wurde dem amtierenden Notar vorgelegt.
12. Daraufhin erschien Cupstone Ltd., eine Gesellschaft unterliegend dem Recht der Britischen Jungferninseln, mit
Gesellschaftssitz in Nerine Chambers, P.O. Box 905, Road Town, Tortola, British Virgin Islands und eingetragen im
Registrar of Corporate Affairs unter der Nummer 1048031 (nachstehend „Cupstone”), vertreten durch Herrn Patrick
Chantrain, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht erstellt am 10. November 2014, welche durch den Bevollmäch-
tigten und den amtierenden Notar unterzeichnet und dieser Urkunde beiliegen bleibt und zusammen mit ihr zur
Registrierung eingereicht werden wird.
Cupstone gab an 15.504 (fünfzehntausendfünfhundertvier) neue Anteile mit einem Nennwert von je EUR 1,- (ein Euro)
zu zeichnen und diese neuen Anteile mittels Bareinlage voll einzuzahlen.
Der Gesamtbetrag in Höhe von EUR 15.504,- (fünfzehntausendfünfhundertvier Euro) stand fortan der Gesellschaft zur
Verfügung. Ein Beweis hierfür wurde dem amtierenden Notar vorgelegt.
13. Daraufhin erschien Future Definite Holdings Limited, eine Gesellschaft unterliegend dem Recht der Britischen
Jungferninseln, mit Gesellschaftssitz in Yamraj Building, P.O. Box 875, Road Town, Tortola, British Virgin Islands und
eingetragen im Registrar of Corporate Affairs unter der Nummer 1794687 (nachstehend „Future Definite Holdings”),
vertreten durch Herrn Patrick Chantrain, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht erstellt am 10. November 2014,
welche durch den Bevollmächtigten und den amtierenden Notar unterzeichnet und dieser Urkunde beiliegen bleibt und
zusammen mit ihr zur Registrierung eingereicht werden wird.
Future Definite Holdings gab an 11.628 (elftausendsechshundertachtundzwanzig) neue Anteile mit einem Nennwert
von je EUR 1,- (ein Euro) zu zeichnen und diese neuen Anteile mittels Bareinlage voll einzuzahlen.
Der Gesamtbetrag in Höhe von EUR 11.628,- (elftausendsechshundertachtundzwanzig Euro) stand fortan der Gesell-
schaft zur Verfügung. Ein Beweis hierfür wurde dem amtierenden Notar vorgelegt.
14. Daraufhin erschien Voit Foundation, eine Stiftung unterliegend dem Recht Liechtensteins, mit Gesellschaftssitz in
Felbaweg 10, FL-9494 Schaan, Liechtenstein und eingetragen im Öffentlichkeitsregister Liechtenstein unter der Nummer
FL-0002.298.950-7 (nachstehend „Voit”), vertreten durch Herrn Patrick Chantrain, aufgrund einer privatschriftlichen
Vollmacht erstellt am 10. November 2014, welche durch den Bevollmächtigten und den amtierenden Notar unterzeichnet
und dieser Urkunde beiliegen bleibt und zusammen mit ihr zur Registrierung eingereicht werden wird.
Voit gab an 7.752 (siebentausendsiebenhundertzweiundfünfzig) neue Anteile mit einem Nennwert von je EUR 1,- (ein
Euro) zu zeichnen und diese neuen Anteile mittels Bareinlage voll einzuzahlen.
Der Gesamtbetrag in Höhe von EUR 7.752,- (siebentausendsiebenhundertzweiundfünfzig Euro) stand fortan der Ge-
sellschaft zur Verfügung. Ein Beweis hierfür wurde dem amtierenden Notar vorgelegt.
182047
L
U X E M B O U R G
15. Daraufhin erschien ARMIGER INVESTMENT Inc., eine Gesellschaft unterliegend dem Recht der Britischen Jung-
ferninseln, mit Gesellschaftssitz in Trinity Chambers, P.O. Box 4301, Road Town, Tortola, British Virgin Islands und
eingetragen im Registrar of Corporate Affairs unter der Nummer 1501659 (nachstehend „Armiger”), vertreten durch
Herrn Patrick Chantrain, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht erstellt am 10. November 2014, welche durch den
Bevollmächtigten und den amtierenden Notar unterzeichnet und dieser Urkunde beiliegen bleibt und zusammen mit ihr
zur Registrierung eingereicht werden wird.
Armiger gab an 5.426 (fünftausendvierhundertsechsundzwanzig) neue Anteile mit einem Nennwert von je EUR 1,- (ein
Euro) zu zeichnen und diese neuen Anteile mittels Bareinlage voll einzuzahlen.
Der Gesamtbetrag in Höhe von EUR 5.426,- (fünftausendvierhundertsechsundzwanzig Euro) stand fortan der Gesell-
schaft zur Verfügung. Ein Beweis hierfür wurde dem amtierenden Notar vorgelegt.
16. Daraufhin erschien Herr Jürg MARQUARD, geboren am 13. Juli 1945, ansässig in Villa Bella Vista, Biswindstrasse
17, 8704 Herrliberg, Schweiz (nachstehend „Herr Marquard“), vertreten durch Herrn Patrick Chantrain, aufgrund einer
privatschriftlichen Vollmacht erstellt am 10. November 2014, welche durch den Bevollmächtigten und den amtierenden
Notar unterzeichnet und dieser Urkunde beiliegen bleibt und zusammen mit ihr zur Registrierung eingereicht werden
wird.
Herr Marquard gab an 7.364 (siebentausenddreihundertvierundsechzig) neue Anteile mit einem Nennwert von je EUR
1,- (ein Euro) zu zeichnen und diese neuen Anteile mittels Bareinlage voll einzuzahlen.
Der Gesamtbetrag in Höhe von EUR 7.364,- (siebentausenddreihundertvierundsechzig Euro) stand fortan der Gesell-
schaft zur Verfügung. Ein Beweis hierfür wurde dem amtierenden Notar vorgelegt.
17. Daraufhin erschien BLACK DOG HOLDINGS Ltd., eine Gesellschaft unterliegend dem Recht der Seychellen, mit
Gesellschaftssitz in Suite 15, 1
st
Floor Oliaji Trade Centre, Francis Rachel Street, P.O. Box 1004, Victoria, Mahé, Seychelles
und eingetragen im Registrar of International Business Companies unter der Nummer 136725 (nachstehend „Black Dog”),
vertreten durch Herrn Patrick Chantrain, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht erstellt am 10. November 2014,
welche durch den Bevollmächtigten und den amtierenden Notar unterzeichnet und dieser Urkunde beiliegen bleibt und
zusammen mit ihr zur Registrierung eingereicht werden wird.
Black Dog gab an 1.938 (eintausendneunhundertachtunddreissig) neue Anteile mit einem Nennwert von je EUR 1,-
(ein Euro) zu zeichnen und diese neuen Anteile mittels Bareinlage voll einzuzahlen.
Der Gesamtbetrag in Höhe von EUR 1.938,- (eintausendneunhundertachtunddreissig Euro) stand fortan der Gesell-
schaft zur Verfügung. Ein Beweis hierfür wurde dem amtierenden Notar vorgelegt.
18. Daraufhin erschien GULF POINT Ltd., eine Gesellschaft unterliegend dem Recht der Mashall Islands, mit Gesell-
schaftssitz in Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands MH96960 und eingetragen
im Office of the Registrar of Corporations unter der Nummer 44482 (nachstehend „Gulf”), vertreten durch Herrn Patrick
Chantrain, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht erstellt am 10. November 2014, welche durch den Bevollmäch-
tigten und den amtierenden Notar unterzeichnet und dieser Urkunde beiliegen bleibt und zusammen mit ihr zur
Registrierung eingereicht werden wird.
Gulf gab an 2.713 (zweitausendsiebenhundertdreizehn) neue Anteile mit einem Nennwert von je EUR 1,- (ein Euro)
zu zeichnen und diese neuen Anteile mittels Bareinlage voll einzuzahlen.
Der Gesamtbetrag in Höhe von EUR 2.713,- (zweitausendsiebenhundertdreizehn Euro) stand fortan der Gesellschaft
zur Verfügung. Ein Beweis hierfür wurde dem amtierenden Notar vorgelegt.
19. Daraufhin erschien Herr Thomas BORER, geboren am 29. Juli 1957 in Basel (Schweiz), ansässig in c/o Borer
Consulting, Seestrasse 83, 8800 Thalwil, Zurich, Schweiz (nachstehend „Herr Borer“), vertreten durch Herrn Patrick
Chantrain, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht erstellt am 10. November 2014, welche durch den Bevollmäch-
tigten und den amtierenden Notar unterzeichnet und dieser Urkunde beiliegen bleibt und zusammen mit ihr zur
Registrierung eingereicht werden wird.
Herr Borer gab an 1.938 (eintausendneunhundertachtunddreissig) neue Anteile mit einem Nennwert von je EUR 1,-
(ein Euro) zu zeichnen und diese neuen Anteile mittels Bareinlage voll einzuzahlen.
Der Gesamtbetrag in Höhe von EUR 1.938,- (eintausendneunhundertachtunddreissig Euro) stand fortan der Gesell-
schaft zur Verfügung. Ein Beweis hierfür wurde dem amtierenden Notar vorgelegt.
20. Daraufhin erschien Herr Rolf FURRER, geboren am 24. April 1962, ansässig in Schlapprig 2A, 8847 Egg, Schweiz
(nachstehend „Herr Furrer“), vertreten durch Herrn Patrick Chantrain, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht er-
stellt am 10. November 2014, welche durch den Bevollmächtigten und den amtierenden Notar unterzeichnet und dieser
Urkunde beiliegen bleibt und zusammen mit ihr zur Registrierung eingereicht werden wird.
Herr Furrer gab an 1.550 (eintausendfünfhundertfünfzig) neue Anteile mit einem Nennwert von je EUR 1,- (ein Euro)
zu zeichnen und diese neuen Anteile mittels Bareinlage voll einzuzahlen.
Der Gesamtbetrag in Höhe von EUR 1.550,- (eintausendfünfhundertfünfzig Euro) stand fortan der Gesellschaft zur
Verfügung. Ein Beweis hierfür wurde dem amtierenden Notar vorgelegt.
Folglich der vorbezeichneten Zeichnungen, stand ein Gesamtbetrag in Höhe von EUR 358.914,- (dreihundertachtund-
fünfzigtausendneunhundertvierzehn Euro) der Gesellschaft fortan zur Verfügung. Ein Beweis hierfür wurde dem amtie-
renden Notar vorgelegt.
182048
L
U X E M B O U R G
<i>Dritter Beschlussi>
Die Alleingesellschafterin hat beschlossen, vorbezeichnete Zeichnungen und Einzahlungen anzunehmen und die
358.914 (dreihundert-achtundfünfzigtausendneunhundertvierzehn) neuen Anteile als voll einbezahlte Anteile den vorbe-
zeichneten zeichnenden Personen zuzuweisen.
<i>Vierter Beschlussi>
Die Generalversammlung hat beschlossen, das Kapital der Gesellschaft auf EUR 408.914,- (vierhundertachttausend-
neunhundertvierzehn Euro), eingeteilt in 408.914 (vierhundertachttausendneunhundertvierzehn) Anteile mit einem
Nennwert von je EUR 1,- (ein Euro), die die in der Satzung der Gesellschaft beschrieben Rechte und Privilegien haben,
festzusetzen.
<i>Fünfter Beschlussi>
Die Generalversammlung hat beschlossen, Artikel fünf (5), sieben (7), neun (9), zwölf (12) und fünfzehn (15) abzuän-
dern.
Artikel fünf (5) wird nunmehr wie folgt lauten:
„ Art. 5. Kapital der Gesellschaft. Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 408.914,- (vierhundertachttausendneunhun-
dertvierzehn Euro), eingeteilt in 408.914 (vierhundertachttausendneunhundertvierzehn) Anteile mit einem Nennwert von
je EUR 1,- (ein Euro).“
Artikel sieben (7) wird nunmehr wie folgt lauten:
„ Art. 7. Gewinnbeteiligung. Sofern (i) die Satzung oder (ii) eine Gesellschaftervereinbarung oder ein ähnlicher zwischen
den Gesellschaftern ggfs. abgeschlossener Vertrag keine abweichende Regelungen enthält, entspricht jedem Anteil ein im
Verhältnis zu der Gesamtzahl der Anteile stehendes Anrecht auf die Aktiva und die Gewinne der Gesellschaft.“
Artikel neun (9) wird nunmehr wie folgt lauten:
„ Art. 9. Übertragung von Gesellschaftsanteilen. Anteile eines Alleingesellschafters sind frei übertragbar.
Bei mehreren Gesellschaftern kann die Übertragung von Anteilen auf Dritte im Wege eines Rechtsgeschäfts unter
Lebenden nur mit Genehmigung durch die Gesellschafterversammlung erfolgen, wobei für eine solche Genehmigung eine
Mehrheit nach Stimmen erreicht werden muss, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten. Für die
Übertragung von Anteilen unter Gesellschaftern der Gesellschaft bedarf es einer solchen Genehmigung nicht.
Die Übertragung der Anteile an Dritte im Falle des Todes eines Gesellschafters bedarf der Zustimmung von mindestens
drei Vierteln der überlebenden Gesellschafter.
In jedem Fall müssen die Bestimmungen des vorliegenden Artikel 9, der Artikel 189 und 190 des abgeänderten Gesetzes
vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften (das „Gesetz von 1915“), sowie die in einer Gesellschafterverein-
barung oder in einem ähnlichen zwischen den Gesellschaftern ggfs. abgeschlossenen Vertrag vorgesehenen Einschrän-
kungen eingehalten werden.“
Absatz vier (4) von Artikel zwölf (12) wird nunmehr wie folgt lauten:
„ Art. 12. Geschäftsführung . (Absatz vier (4)). Der Geschäftsführer oder, bei einer Mehrheit von Geschäftsführern,
der Geschäftsführerrat, ist zuständig in allen Angelegenheiten, die nicht ausdrücklich durch Gesetz, durch diese Satzung
oder durch eine Gesellschaftervereinbarung oder in einem ähnlichen zwischen den Gesellschaftern ggfs. abgeschlossenen
Vertrag enthaltenen Bestimmungen der Gesellschafterversammlung zugewiesen sind.“
Artikel fünfzehn (15) wird nunmehr wie folgt lauten:
„ Art. 15. Stimmrecht der Gesellschafter, Beschlussfähigkeit und Mehrheit. Ein Alleingesellschafter vereinigt alle Be-
fugnisse der Gesellschafterversammlung auf sich.
Im Falle einer Mehrheit von Gesellschaftern hat jeder Gesellschafter das Recht, an gemeinsamen Entscheidungen teil-
zunehmen, unabhängig von seiner Kapitalbeteiligung. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie Anteile auf ihn
entfallen.
Die Mehrheitsvoraussetzungen für Beschlussfassungen der Gesellschafter werden durch das Gesetz von 1915 sowie
den in einer Gesellschaftervereinbarung oder in einem ähnlichen zwischen den Gesellschaftern ggfs. abgeschlossenen
Vertrag enthaltenen Bestimmungen, festgesetzt.”
<i>Kosteni>
Die Kosten und Auslagen, die der Gesellschaft in Zusammenhang mit vorliegender Urkunde entstehen oder die sie zu
tragen hat, belaufen sich auf ungefähr EUR 1.800,- (eintausendachthundert Euro).
WORÜBER Urkunde erstellt in Luxemburg am Datum, wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnete Notar, der der englischen Sprache mächtig ist, erklärt hiermit, dass auf Ersuchen der erschienenen
Parteien diese Urkunde in englischer Sprache verfasst und mit einer deutschen Übersetzung versehen ist und dass im
Falle einer Abweichung des englischen vom deutschen Text der englische Text maßgebend ist.
182049
L
U X E M B O U R G
Nachdem die Urkunde den erschienenen Personen, welche dem Notar mit Nachname, Vorname, Personenstand und
Adresse bekannt sind, vorgelesen wurde, haben die erschienenen Personen zusammen mit dem Notar die vorliegende
Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: P. CHANTRAIN, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 12 novembre 2014. Relation: DIE/2014/14334. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.
<i>Le Receveuri> (signé) pd: RECKEN.
Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Memorial C.
Diekirch, den 13. November 2014.
Référence de publication: 2014177649/595.
(140203376) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2014.
MD International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 191.849.
STATUTEN
Im Jahre zweitausendvierzehn, den sechsten Tag im Monat November.
Vor dem unterzeichnenden Notar Paul BETTINGEN, mit dem Amtssitze zu Niederanven.
Ist erschienen:
Herr Mark BRESLAV, kaufmännischer Angestellter, geboren am 02. Dezember 1967 in Riga (LV), wohnhaft in D-10785
Berlin, Clara-Wieck-Str. 3, hier vertreten durch Frau Katja Vogel, kaufmännische Angestellte, beruflich wohnhaft in L-1736
Senningerberg, 5, Rue Heienhaff laut den Bedingungen der Vollmacht, welche von den Bevollmächtigten und dem unter-
zeichnenden Notar “ne varietur” gegengezeichnet wurde und dem Notarakt beigebogen verbleibt.
Vorbenannte Person, vertreten wie vorerwähnt, ersucht den unterzeichnenden Notar, die Satzungen einer von ihr zu
gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu dokumentieren.
Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital
Art. 1. Es wird eine anonyme Aktiengesellschaft gegründet unter der Bezeichnung:
"MD INTERNATIONAL S.A.".
Die Gesellschaft kann einen einzigen oder mehrere Gesellschafter haben. Solange die Gesellschaft nur einen Gesell-
schafter hat, kann diese durch einen einzigen Verwalter verwaltet werden, welcher nicht der einzige Gesellschafter zu
sein braucht.
Der Tod, die Aufhebung der Zivilrechte, der Konkurs, die Liquidation oder der Bankrott des einzigen Gesellschafters
lösen die Gesellschaft nicht auf.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Niederanven.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates oder des einzigen Verwalters können Niederlassungen, Zweigstellen,
Agenturen und Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates oder des einzigen Verwalters kann der Sitz der Gesellschaft an jede
andere Adresse innerhalb der Gemeinde des Gesellschaftssitzes verlegt werden.
Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch dieses
Sitzes mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet wer-
den, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins
Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft,
die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.
Die Bekanntmachung von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen Ge-
schäftsführung beauftragt sind.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Art. 4. Der Gesellschaftszweck ist der Vertrieb von Fitnessprodukten, wie Kleidung, Getränke und Accessoires.
Des Weiteren beschäftigt sich die Gesellschaft mit der Erbringung von weiteren mit dem Gesellschaftszweck zusam-
menhängenden Dienstleistungen jeglicher Art, inklusive Beratungsdienstleistungen.
Die Gesellschaft kann sich an der Gründung und Entwicklung jeder finanziellen, industriellen oder kommerziellen
Gesellschaft beteiligen und ihr alle Mithilfe geben, sei es durch Kredite, Garantien, oder auf andere Art und Weise. Die
Gesellschaft kann den Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, auf jede Art Darlehen und Unters-
tützung geben.
182050
L
U X E M B O U R G
Darüber hinaus kann die Gesellschaft generell alle Geschäfte, die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in
Verbindung stehen oder mit allen vergleichbaren oder verbundenen Zwecken, welche der Erweiterung oder die Entwic-
klung des Gesellschaftszweckes fördern können, vornehmen.
Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einunddreißig tausend Euro (EUR 31.000,-), eingeteilt in einhundert (100)
Aktien mit einem Nennwert von je dreihundertzehn Euro (EUR 310,-).
Die Gesellschaftsaktien sind Namensaktien.
Ein Register der Namensaktien wird am Gesellschaftssitz geführt, wo es jedem Aktionär zur Einsicht zur Verfügung
steht. Dieses Register enthält alle durch Artikel 39 des Gesetzes von 1915 vorgeschriebenen Auskünfte. ¨ Das Eigentum
an einer Namensaktie wird durch die Eintragung in das Aktienregister begründet.
Die Gesellschaft kann zum Rückkauf Ihrer eigenen Aktien schreiten, unter den durch das Gesetz vorgesehenen Be-
dingungen.
Unter den gesetzlichen Bedingungen kann ebenfalls das Gesellschaftskapital erhöht oder erniedrigt werden.
Verwaltung - Überwachung
Art. 6. Wenn die Gesellschaft durch einen einzigen Gesellschafter gegründet wurde oder wenn durch Generalver-
sammlung festgestellt wird, dass die Gesellschaft nur einen einzigen Gesellschafter hat, kann die Gesellschaft durch einen
einzigen Verwalter verwaltet werden, der „einziger Verwalter“ genannt wird, bis zur nächsten ordentlichen Generalver-
sammlung, welche das Vorhandensein von mehr als einem Aktionär feststellt.
Wenn die Gesellschaft mehr als einen Gesellschafter hat wird diese durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus
mindestens drei Mitgliedern besteht, die keine Aktionäre sein müssen. In diesem Fall muss die Generalversammlung
zusätzlich zu dem einzigen Verwalter zwei (2) neue Verwalter ernennen. Der einzige Verwalter beziehungsweise die
Verwalter werden für eine Dauer ernannt, die sechs Jahre nicht überschreiten darf. Sie können von der Generalver-
sammlung wiedergewählt und jederzeit abberufen werden.
Jeder Verweis auf den Verwaltungsrat in vorliegender Satzung ist ein Verweis auf den einzigen Verwalter (wenn die
Gesellschaft einen einzigen Gesellschafter hat) solange die Gesellschaft einen einzigen Gesellschafter hat.
Wenn eine juristische Person Verwalter der Gesellschaft ist, muss diese einen ständigen Vertreter bestimmen, welcher
die juristische Person gemäss Artikel 51bis des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, so wie
dies abgeändert wurde, vertritt.
Der/die Verwalter werden durch die Generalversammlung ernannt. Die Gesellschafter bestimmen ebenfalls die Anzahl
der Verwalter, ihre Vergütung und die Dauer ihres Mandates.
Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates durch Tod, Pension oder jeden anderen Grund, frei, so können
die verbleibenden Mitglieder durch einfache Stimmenmehrheit das frei gewordene Amt bis zur nächsten Generalver-
sammlung der Aktionäre besetzen. Falls kein Verwalter verfügbar ist, wird durch den Prüfungskommissar schnell eine
Generalversammlung einberufen, um einen neuen Verwalter zu ernennen.
Art. 7. Der Verwaltungsrat beziehungsweise der einzige Verwalter hat die weitestgehenden Befugnisse alle Verwal-
tungs- und Verfügungshandlungen durchzuführen, die im Interesse der Gesellschaft sind.
Alle Handlungen, die nicht ausdrücklich durch gegenwärtige Satzungen und das Gesetz, der Generalversammlung vor-
behalten sind, fallen der Kompetenz des Verwaltungsrates beziehungsweise des einzigen Verwalters zu.
Art. 8. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Wenn kein Vorsitzender vorhanden
ist, kann der Vorsitz der Versammlung einem anwesenden Verwalter anvertraut werden.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei
Vollmacht zwischen Mitgliedern möglich ist. Die Verwaltungsratsmitglieder können die Vollmacht schriftlich, fernschrift-
lich, telegraphisch oder per Telefax geben In Dringlichkeitsfällen können die Verwaltungsratsmitglieder ihre Stimme auch
schriftlich, fernschriftlich, telegraphisch oder per Telefax abgeben Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden durch
einfache Stimmenmehrheit gefasst. Im Falle von Gleichstand ist die Stimme des Vorsitzenden der Versammlung entschei-
dend.
Die Beschlüsse, die durch den einzigen Verwalter gefasst werden haben die gleiche Ausführungskraft wie diejenigen,
die durch den Verwaltungsrat gefasst werden und werden in Protokollen festgehalten, welche durch den einzigen Ver-
walter unterschrieben werden und wovon Kopien und Auszüge angefertigt werden können.
Der erste Vorsitzende wird von der Generalversammlung gewählt.
Art. 9. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern seine Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung sowie der Ver-
tretung der Gesellschaft in der Verwaltung dieser Geschäfte, übertragen.
Der Verwaltungsrat beziehungsweise der einzige Verwalter kann ausserdem jedwelcher Person, die nicht Verwalter
sein muss, jedwelche Spezialvollmacht erteilen sowie Vertreter und Angestellte ernennen und abberufen und ihren Lohn
festsetzen.
Art. 10. Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsrats-
mitgliedern, in der täglichen Geschäftsführung durch die Einzelunterschrift des delegierten Verwalters, beziehungsweise
182051
L
U X E M B O U R G
durch die Unterschrift des einzigen Verwalters oder durch die gemeinsame oder alleinige Unterschrift eines im Rahmen
der ihm erteilten Vollmachten handelnden Bevollmächtigten des Verwaltungsrates beziehungsweise des einzigen Verwal-
ters.
Art. 11. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannte Kom-
missare überwacht, die ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt.
Die Dauer der Amtszeit der Kommissare, wird von der Generalversammlung festgelegt. Sie kann jedoch sechs Jahre
nicht überschreiten.
Geschäftsjahr - Generalversammlung
Art. 12. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres.
Art. 13. Für den Fall, dass es nur einen Gesellschafter (einziger Gesellschafter) gibt, übt dieser im Laufe der ordnungs-
gemäss abgehaltenen Generalversammlungen sämtliche Befugnisse aus, welche laut dem Gesetz vom 10. August 1915
über die Handelsgesellschaften der Generalversammlung obliegen.
Die Generalversammlungen werden gemäss den gesetzlichen Bestimmungen einberufen. Sie sind nicht nötig, wenn alle
Gesellschafter bei der Versammlung anwesend oder vertreten sind und wenn sie erklären vorab von der Tagesordnung
Kenntnis genommen zu haben.
Der Verwaltungsrat kann festlegen, dass nur die Aktionäre zur Generalversammlung zugelassen werden, die fünf Ka-
lendertage vor dem festgelegten Datum ihre Aktien hinterlegt haben. Jeder Aktionär kann persönlich oder mittels eines
Bevollmächtigten, welcher nicht Aktionär sein muss, abstimmen.
Jede Aktie gibt anrecht auf eine Stimme.
Art. 14. Jede ordentliche oder ausserordentliche Generalversammlung kann nur gültig über die Tagesordnung befinden,
wenn die Gesellschafter in den gesetzlich vorgesehenen Verhältnissen anwesend oder vertreten sind.
Die Generalversammlung hat die weitestgehenden Befugnisse, um alle Handlungen im Interesse der Gesellschaft zu
tätigen oder zu ratifizieren.
Art. 15. Die Generalversammlung bestimmt über Verwendung und die Zuteilung der Gewinne.
Der Verwaltungsrat beziehungsweise der einzige Verwalter ist ermächtigt Zwischendividenden auszuschütten gemäss
den gesetzlichen Bestimmungen.
Art. 16. Die jährliche Generalversammlung tritt in dem im Einberufungsschreiben genannten Ort zusammen und zwar
am letzten Donnerstag des Monats Juni, um 14 Uhr.
Falls der vorgenannte Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.
Art. 17. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des
Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften sowie auf die späteren Änderungen.
<i>Bescheinigungi>
Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über
die Handelsgesellschaften erfüllt sind.
<i>Vorübergehende Bestimmungeni>
- Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2015.
- Die erste ordentliche Generalversammlung findet im Jahre 2016 statt.
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwär-
tiger Gründung erwachsen, auf eintausendeinhundert Euro (EUR 1.100,-).
<i>Kapitalzeichnungi>
Die gesamten einhundert (100) Aktien wurden durch Herr Mark BRESLAV, vorgenannt, gezeichnet und zu einhundert
Prozent in bar eingezahlt, so dass der Gesellschaft ab heute die Summe von einunddreißig tausend Euro (EUR 31.000,-)
zur Verfügung steht, worüber dem Notar der Nachweis erbracht wurde.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Sodann hat der Erschienene sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengefunden und folgende
Beschlüsse gefasst:
1.- Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird festgelegt auf einen, diejenige der Kommissare wird festgelegt auf
einen.
2.- Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden mit der ordentlichen Jahresgeneralver-
sammlung des Jahres 2019.
182052
L
U X E M B O U R G
3.- Zum einzigen Verwalter wird ernannt Herr Mark BRESLAV, vorbenannt.
4.- Zum Kommissar wird ernannt:
Lux-Fiduciaire S.A., mit Sitz in L-2763 Luxembourg, 12, Rue Sainte Zithe, eingetragen im Firmen- und Handelsregister
Luxemburg unter der Nummer B65819.
6.- Der Gesellschaftssitz befindet sich auf folgender Adresse:
L-1736 Senningerberg, 5, Rue Heienhaff.
<i>Bevollmächtigungi>
Die Erschienenen, handelnd in gemeinsamem Interesse, erteilen hiermit einem jeden Angestellten des unterzeichneten
Notars Spezialvollmacht, in ihrem Namen jegliche etwaige Berichtigungsurkunde gegenwärtiger Urkunde aufzunehmen.
Worüber Urkunde, Aufgenommen in Senningerberg, Im Jahre, Monat und Tage wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung, hat der vorgenannte Komparent zusammen mit dem instrumentierenden Notar die vorliegende
Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: Katja Vogel, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 7 novembre 2014. LAC / 2014 / 52280. Reçu 75.-e.
<i>Le Receveuri>
(signé): Irène Thill.
- Für gleichlautende Kopie - Ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, den 13. November 2014.
Référence de publication: 2014177815/169.
(140203489) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2014.
Bil Manage Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 178.517.
In the year two thousand and fourteen, on the sixth day of the month of November.
Before Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
There appeared
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, société anonyme, with registered office in L-2953 Luxembourg,
69, route d’Esch, RCS Luxembourg B-6307,
here represented by Mr Antonis ANASTASIOU, employee, residing professionally at 42, rue de la Vallée, L-2661
Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on the 5
th
of November 2014, which proxy will remain attached to the
present deed.
acting as sole shareholder of BIL MANAGE INVEST S.A., a société anonyme governed by the laws of Luxembourg,
with registered office at 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 178.517, incorporated following
a deed received by the notary Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, dated 28 June 2013, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2081 of 27 August 2013, and the Articles of Association have
been amended latest pursuant to a deed of the undersigned notary, notary residing in Luxembourg, on May 7
th
, 2014,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1855 of July 17
th
, 2014.
The sole shareholder then declared and asked the notary to take formal note:
I. That the company has not issued bonds.
II. That the agenda of the present reads as following:
1. Amendment of Article 3 of the articles of incorporation as follows:
“The principal object of the Company is:
1) the management of Luxembourg and foreign undertakings for collective investment in transferable securities
(“UCITS”) authorized according to EU Directive 2009/65/EC and the additional management of other Luxembourg and
foreign undertakings for collective investment (“UCIs”), in accordance with Article 101(2) and Annex II of the Luxembourg
Law of 17 December 2010 relating to undertakings for collective investment (the “2010 Law”); and
2) the performance, for Luxembourg and foreign alternative investment funds (“AIFs”) within the meaning of EU
Directive 2011/61/EU of management functions, administration functions, marketing functions and other activities related
to the assets of AIFs, in accordance with Article 5(2) and Annex I of the Luxembourg Law of 12 July 2013 relating to
alternative investment fund managers (the “2013 Law”). The Company will not provide the services of (a) management
of portfolios of investments on a discretionary client-by-client basis, (b) investment advice, (c) safekeeping and adminis-
tration in relation to shares or units of collective investment undertakings or (d) the reception and transmission of orders
182053
L
U X E M B O U R G
in relation to financial investments as contemplated in Article 101 (3) of the 2010 Law and/or Article 5 (4) of the 2013
Law.
The Company may provide the above mentioned management, administration and marketing services also to the
subsidiaries of UCITS, UCIs and AIFs to which it provides services, including domiciliation and administration support
services.
The Company may perform all or part of the above activities to UCITS, UCIs and AIFs and/or to other management
companies or alternative fund managers as delegate.
The Company may perform permitted activities outside of Luxembourg through the free provision of services and/or
through the opening of branches.
More generally, the Company may carry out any activities connected with the services it provides to UCITS, UCIs and
AIFs to the furthest extent permitted by the 2010 Law, the 2013 Law and any other applicable laws and regulations.
The Company may carry out any activities connected directly or indirectly to, and/or deemed useful and/or necessary
for the accomplishment of its object, remaining, however, within the limitations set forth in, but to the furthest extent
permitted by, the provisions of the 2010 Law and the 2013 Law.
For the avoidance of doubt, the Company may act as manager (gérant) of partnerships (including corporate partnerships
limited by shares, common limited corporate partnerships or special limited partnerships) within the meaning of article
107, article 17 and article 22-3 of the 1915 Law or the equivalent under the relevant law.”
2. Amendment of Article 12 of the articles of incorporation as follows:
“The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from its members a vice-
chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping the minutes
of the meetings of the board of directors and of the shareholders.
The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of
meeting.
The chairman of the board of directors shall preside at all meetings of the board of directors; in his absence, the
shareholders or the directors may appoint another director and, in the case of a general meeting, in the absence of a
director, any other person, as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of directors must be given to directors twenty-four hours at least in
advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be waived in case of assent of each director in writing,
by e-mail or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice will be required for a
board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of directors. Any
director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by telegram or facsimile another
director as his proxy.
A director may represent more than one of his colleagues. Any director may participate in a meeting of the board of
directors by conference call or video-conference or by other similar means of communication equipment, provided that
such means permit such director to be properly identified and whereby all persons participating in the meeting can hear
one another on a continuous basis and allowing an effective participation of all such persons in the meeting. The partici-
pation in a meeting by such means of communication is deemed to be held at the registered office of the Company.
Except as stated below, the board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors
is present in person or represented at such meeting. In the event that in any meeting the number of votes for or against
a resolution shall be equal, the chairman shall have a casting vote.
The board of directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by telegram or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety will form
the minutes giving evidence of the resolution. The date of such circular resolutions shall be the date of the last signature.”
3. Miscellaneous.
III. Then the sole shareholder takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder after having stated that the company has not issued convertible bonds, resolves to amend article
3 (purpose) of the Articles of Association, so that it should henceforth read as follows:
“The principal object of the Company is:
1) the management of Luxembourg and foreign undertakings for collective investment in transferable securities
(“UCITS”) authorized according to EU Directive 2009/65/EC and the additional management of other Luxembourg and
foreign undertakings for collective investment (“UCIs”), in accordance with Article 101(2) and Annex II of the Luxembourg
Law of 17 December 2010 relating to undertakings for collective investment (the “2010 Law”); and
2) the performance, for Luxembourg and foreign alternative investment funds (“AIFs”) within the meaning of EU
Directive 2011/61/EU of management functions, administration functions, marketing functions and other activities related
to the assets of AIFs, in accordance with Article 5(2) and Annex I of the Luxembourg Law of 12 July 2013 relating to
alternative investment fund managers (the “2013 Law”). The Company will not provide the services of (a) management
182054
L
U X E M B O U R G
of portfolios of investments on a discretionary client-by-client basis, (b) investment advice, (c) safekeeping and adminis-
tration in relation to shares or units of collective investment undertakings or (d) the reception and transmission of orders
in relation to financial investments as contemplated in Article 101 (3) of the 2010 Law and/or Article 5 (4) of the 2013
Law.
The Company may provide the above mentioned management, administration and marketing services also to the
subsidiaries of UCITS, UCIs and AIFs to which it provides services, including domiciliation and administration support
services.
The Company may perform all or part of the above activities to UCITS, UCIs and AIFs and/or to other management
companies or alternative fund managers as delegate.
The Company may perform permitted activities outside of Luxembourg through the free provision of services and/or
through the opening of branches.
More generally, the Company may carry out any activities connected with the services it provides to UCITS, UCIs and
AIFs to the furthest extent permitted by the 2010 Law, the 2013 Law and any other applicable laws and regulations.
The Company may carry out any activities connected directly or indirectly to, and/or deemed useful and/or necessary
for the accomplishment of its object, remaining, however, within the limitations set forth in, but to the furthest extent
permitted by, the provisions of the 2010 Law and the 2013 Law.
For the avoidance of doubt, the Company may act as manager (gérant) of partnerships (including corporate partnerships
limited by shares, common limited corporate partnerships or special limited partnerships) within the meaning of article
107, article 17 and article 22-3 of the 1915 Law or the equivalent under the relevant law.”
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder resolves to amend Article 12 of the articles of incorporation as follows:
“The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from its members a vice-
chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping the minutes
of the meetings of the board of directors and of the shareholders.
The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of
meeting.
The chairman of the board of directors shall preside at all meetings of the board of directors; in his absence, the
shareholders or the directors may appoint another director and, in the case of a general meeting, in the absence of a
director, any other person, as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of directors must be given to directors twenty-four hours at least in
advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be waived in case of assent of each director in writing,
by e-mail or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice will be required for a
board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of directors. Any
director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by telegram or facsimile another
director as his proxy.
A director may represent more than one of his colleagues. Any director may participate in a meeting of the board of
directors by conference call or video-conference or by other similar means of communication equipment, provided that
such means permit such director to be properly identified and whereby all persons participating in the meeting can hear
one another on a continuous basis and allowing an effective participation of all such persons in the meeting. The partici-
pation in a meeting by such means of communication is deemed to be held at the registered office of the Company.
Except as stated below, the board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors
is present in person or represented at such meeting. In the event that in any meeting the number of votes for or against
a resolution shall be equal, the chairman shall have a casting vote.
The board of directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by telegram or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety will form
the minutes giving evidence of the resolution. The date of such circular resolutions shall be the date of the last signature.”
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company, as a result of this
document are estimated at one thousand four hundred Euro (EUR 1.300.-).
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, the present
deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing person and in case of
divergencies between the English text and the French translation, the English version will be prevailing.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, known to the notary by his name, surname, civil status and
residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the present original deed
182055
L
U X E M B O U R G
Follows the French translation/ Suit la version française:
L'an deux mil quatorze, le six novembre.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, société anonyme, avec siège social à L-2953 Luxembourg, 69, route
d’Esch, inscrite au R.C.S Luxembourg B 6307,
ici représentée par Mr Antonis ANASTASIOU, employé, demeurant professionnellement au 42, rue de la Vallée,
L-2661 Luxembourg,
en vertu d’une procuration lui donnée en date du 5 novembre 2014, laquelle procuration restera annexe au présent
acte,
en sa qualité de seule et unique actionnaire de BIL MANAGE INVEST S.A., une société anonyme régie par le droit
luxembourgeois, ayant son siège social au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, inscrite au R.C.S. Luxembourg B
178.517,
constituée suivant acte du notaire Jean-Joseph WAGNER en date du 28 juin 2013, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations sous le numéro 2081 du 27 août 2013, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois
suivant acte du notaire instrumentaire en date du 7 mai 2014, publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
numéro 1855 du 17 juillet 2014.
Ensuite l’actionnaire unique déclare et prie le notaire d’acter:
I. Que la société n’a pas émis d’emprunts obligataires.
II. Que l’ordre de jour des présentes est conçu comme suit:
1. Modification de l’Article 3 des Statuts de la Société comme suit:
“La Société a pour objet principal:
1) la gestion d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières («OPCVM») luxembourgeois et étrangers agréés
conformément à la directive européenne 2009/65/CE et des activités supplémentaires de gestion d’autres organismes de
placement collectif («OPC») luxembourgeois et étrangers, conformément à l’article 101(2) et l’Annexe II de la loi lu-
xembourgeoise du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif (la «Loi de 2010»); et
2) l’exercice, pour des fonds d’investissement alternatifs («FIA») luxembourgeois et étrangers au sens de la directive
européenne 2011/61/UE de fonctions de gestion, d’administration et de commercialisation et d’autres activités liées aux
actifs de FIA, conformément à l’article 5(2) et à l’annexe I de la loi luxembourgeoise du 12 juillet 2013 concernant les
gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (la «Loi de 2013»).
La Société ne fournira pas les services de (a) gestion de portefeuilles d’investissement sur une base discrétionnaire et
individualisée (b) conseil en investissement, (c) garde et administration pour des parts ou actions d’organismes de place-
ment collectif ou (d) réception et transmission d’ordres portant sur des instruments financiers au sens de l’article 101(3)
de la Loi de 2010 et/ou de l’article 5(4) de la Loi de 2013.
La Société peut également fournir les services susmentionnés de gestion, d’administration et de commercialisation aux
filiales d’OPCVM, d’OPC et de FIA auxquels elle fournit des services, y compris des services de domiciliation et de support
administratif.
La Société pourra exercer tout ou partie des activités susmentionnées pour des OPCVM, OPC et FIA et pour d’autres
société de gestion ou gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs en tant que délégué.
La Société pourra exercer des activités autorisées en dehors du Luxembourg par voie de prestation libre de services
et/ou par l’établissement de succursales.
De manière plus générale, la Société peut exercer toute activité liée aux services qu'elle fournit aux OPCVM, OPC et
FIA dans la mesure la plus large permise par la Loi de 2010, la Loi de 2013 et toute autre loi et réglementation applicable.
La Société peut exercer toute activité liée directement ou indirectement à, et/ou jugée utile et/ou nécessaire à la
réalisation de son objet mais ce, toujours dans les limites prescrites et dans la mesure la plus large permise par les
dispositions de la Loi de 2010 et de la Loi de 2013.
Afin d’éviter tout doute, la Société peut agir en tant que gérant de sociétés en commandite (y compris de sociétés en
commandite par actions, de sociétés en commandite simple ou de sociétés en commandite spéciale) au sens de l’article
107, l’article 17 et l’article 22-3 de la Loi de 1915 ou de l’équivalent en vertu de la loi applicable.”
2. Modification de l’Article 12 des Statuts de la Société comme suit:
“ Art. 12. Réunions du Conseil. Le conseil d'administration choisira un président parmi ses membres. Il peut également
choisir parmi eux un vice-président. Il peut en outre choisir un secrétaire, qui ne doit pas nécessairement être un admi-
nistrateur, qui sera responsable de dresser les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées
des actionnaires.
Le conseil d'administration se réunira sur convocation du président, ou de deux administrateurs, au lieu indiqué sur
l’avis de convocation.
182056
L
U X E M B O U R G
Le président du conseil d'administration présidera toutes les réunions du conseil d'administration; en son absence, les
actionnaires ou les administrateurs peuvent nommer un autre administrateur et, en cas d'assemblée générale, en l’absence
de tout administrateur, toute autre personne, en tant que président pro tempore par vote de la majorité présente à l’une
quelconque de ces assemblées.
Un avis de convocation écrit du conseil d'administration doit être remis aux administrateurs au moins vingt-quatre
heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les motifs de l’urgence seront
mentionnés dans l’avis de convocation. Il est possible de déroger à cet avis de convocation si chaque administrateur y
consent par écrit, par courrier électronique ou facsimile, ou tout autre moyen de communication similaire. Un avis de
convocation spécial sera requis pour qu'une réunion du conseil soit tenue à une date et un lieu déterminés dans une
résolution antérieure adoptée par le conseil d'administration. Tout administrateur peut agir à toute réunion du conseil
d'administration en nommant par écrit, par télégramme ou fac-similé un autre administrateur en tant que mandataire.
Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues. Tout administrateur peut participer à une réunion du
conseil d’administration par conférence téléphonique ou vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication
similaire grâce auquel toutes les personnes participant à la réunion peuvent s’entendre les unes les autres de façon continue
et qui permet la participation effective de toutes lesdites personnes à la réunion, à condition que ce moyen permette à
cet administrateur d’être correctement identifié. La participation à une réunion par le biais de ce type de moyen de
communication est réputée avoir lieu au siège social de la Société.
À l’exception des cas mentionnés ci-dessous, le conseil d'administration peut délibérer ou agir valablement uniquement
si au moins la majorité des administrateurs est présente en personne ou représentée à ladite réunion. Au cas où, lors
d'une quelconque réunion, le nombre de votes pour ou contre une résolution est identique, le président bénéficiera d'une
voix prépondérante.
Le conseil d'administration peut, à l’unanimité, adopter des résolutions par voie de circulaire lorsqu'il exprime son
accord par écrit, par télégramme ou fac-similé, ou tout autre moyen de communication similaire, devant être confirmé
par écrit. L'intégralité constituera le procès-verbal servant de preuve de la résolution. La date des résolutions circulaires
de ce type sera la date de la dernière signature.”
3. Divers.
III. ENSUITE L’ACTIONNAIRE UNIQUE A PRIS LA RESOLUTION SUIVANTE:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée, après avoir constaté que la société n’a pas émis d’emprunt obligataire, décide de modifier l’article 3 des
statuts relatif à l’objet social pour lui donner la teneur nouvelle suivante:
“La Société a pour objet principal:
1) la gestion d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières («OPCVM») luxembourgeois et étrangers agréés
conformément à la directive européenne 2009/65/CE et des activités supplémentaires de gestion d’autres organismes de
placement collectif («OPC») luxembourgeois et étrangers, conformément à l’article 101(2) et l’Annexe II de la loi lu-
xembourgeoise du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif (la «Loi de 2010»); et
2) l’exercice, pour des fonds d’investissement alternatifs («FIA») luxembourgeois et étrangers au sens de la directive
européenne 2011/61/UE de fonctions de gestion, d’administration et de commercialisation et d’autres activités liées aux
actifs de FIA, conformément à l’article 5(2) et à l’annexe I de la loi luxembourgeoise du 12 juillet 2013 concernant les
gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (la «Loi de 2013»).
La Société ne fournira pas les services de (a) gestion de portefeuilles d’investissement sur une base discrétionnaire et
individualisée (b) conseil en investissement, (c) garde et administration pour des parts ou actions d’organismes de place-
ment collectif ou (d) réception et transmission d’ordres portant sur des instruments financiers au sens de l’article 101(3)
de la Loi de 2010 et/ou de l’article 5(4) de la Loi de 2013.
La Société peut également fournir les services susmentionnés de gestion, d’administration et de commercialisation aux
filiales d’OPCVM, d’OPC et de FIA auxquels elle fournit des services, y compris des services de domiciliation et de support
administratif.
La Société pourra exercer tout ou partie des activités susmentionnées pour des OPCVM, OPC et FIA et pour d’autres
société de gestion ou gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs en tant que délégué.
La Société pourra exercer des activités autorisées en dehors du Luxembourg par voie de prestation libre de services
et/ou par l’établissement de succursales.
De manière plus générale, la Société peut exercer toute activité liée aux services qu'elle fournit aux OPCVM, OPC et
FIA dans la mesure la plus large permise par la Loi de 2010, la Loi de 2013 et toute autre loi et réglementation applicable.
La Société peut exercer toute activité liée directement ou indirectement à, et/ou jugée utile et/ou nécessaire à la
réalisation de son objet mais ce, toujours dans les limites prescrites et dans la mesure la plus large permise par les
dispositions de la Loi de 2010 et de la Loi de 2013.
Afin d’éviter tout doute, la Société peut agir en tant que gérant de sociétés en commandite (y compris de sociétés en
commandite par actions, de sociétés en commandite simple ou de sociétés en commandite spéciale) au sens de l’article
107, l’article 17 et l’article 22-3 de la Loi de 1915 ou de l’équivalent en vertu de la loi applicable.”
182057
L
U X E M B O U R G
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’Article 12 des Statuts de la Société comme suit:
“ Art. 12. Réunions du Conseil. Le conseil d'administration choisira un président parmi ses membres. Il peut également
choisir parmi eux un vice-président. Il peut en outre choisir un secrétaire, qui ne doit pas nécessairement être un admi-
nistrateur, qui sera responsable de dresser les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées
des actionnaires.
Le conseil d'administration se réunira sur convocation du président, ou de deux administrateurs, au lieu indiqué sur
l’avis de convocation.
Le président du conseil d'administration présidera toutes les réunions du conseil d'administration; en son absence, les
actionnaires ou les administrateurs peuvent nommer un autre administrateur et, en cas d'assemblée générale, en l’absence
de tout administrateur, toute autre personne, en tant que président pro tempore par vote de la majorité présente à l’une
quelconque de ces assemblées.
Un avis de convocation écrit du conseil d'administration doit être remis aux administrateurs au moins vingt-quatre
heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les motifs de l’urgence seront
mentionnés dans l’avis de convocation. Il est possible de déroger à cet avis de convocation si chaque administrateur y
consent par écrit, par courrier électronique ou facsimile, ou tout autre moyen de communication similaire. Un avis de
convocation spécial sera requis pour qu'une réunion du conseil soit tenue à une date et un lieu déterminés dans une
résolution antérieure adoptée par le conseil d'administration. Tout administrateur peut agir à toute réunion du conseil
d'administration en nommant par écrit, par télégramme ou fac-similé un autre administrateur en tant que mandataire.
Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues. Tout administrateur peut participer à une réunion du
conseil d’administration par conférence téléphonique ou vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication
similaire grâce auquel toutes les personnes participant à la réunion peuvent s’entendre les unes les autres de façon continue
et qui permet la participation effective de toutes lesdites personnes à la réunion, à condition que ce moyen permette à
cet administrateur d’être correctement identifié. La participation à une réunion par le biais de ce type de moyen de
communication est réputée avoir lieu au siège social de la Société.
À l’exception des cas mentionnés ci-dessous, le conseil d'administration peut délibérer ou agir valablement uniquement
si au moins la majorité des administrateurs est présente en personne ou représentée à ladite réunion. Au cas où, lors
d'une quelconque réunion, le nombre de votes pour ou contre une résolution est identique, le président bénéficiera d'une
voix prépondérante.
Le conseil d'administration peut, à l’unanimité, adopter des résolutions par voie de circulaire lorsqu'il exprime son
accord par écrit, par télégramme ou fac-similé, ou tout autre moyen de communication similaire, devant être confirmé
par écrit. L'intégralité constituera le procès-verbal servant de preuve de la résolution. La date des résolutions circulaires
de ce type sera la date de la dernière signature.”
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société en raison du
présent acte sont évalués à environ mille quatre cents Euros (EUR 1.400.-).
Le notaire instrumentaire qui connaît la langue anglaise déclare par les présentes que sur demande du mandataire de
la société comparante le présent acte est rédigé dans la langue anglaise suivie d’une traduction française. Sur demande du
même comparant, il est déterminé qu'en cas de divergences entre le texte française et le texte anglais, le texte anglais
fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la société comparante, connu du notaire par son nom,
prénom, état et demeure, ce dernier a signé avec nous notaire le présent acte.
Signé: A. Anastasiou et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 7 novembre 2014. Relation: LAC/2014/52262. Reçu soixante-quinze euros
Eur 75.-
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Carole FRISING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d’inscription au Registre de
Commerce.
Luxembourg, le 18 novembre 2014.
Référence de publication: 2014178289/315.
(140204473) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2014.
182058
L
U X E M B O U R G
MCP III Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 90.733,00.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 154.543.
In the year two thousand and fourteen, on the thirtieth day of September,
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held
an Extraordinary General Meeting of the sole shareholder of "MCP III Investment S.à r.l." (the “Company”), a Luxem-
bourg "société à responsabilité limitée", having its registered office at 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg,
Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 154.543,
incorporated by a notarial deed enacted on 6 July 2010, published in Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
number 1828 of 7 September 2010 and lastly amended by a notarial deed enacted on 14 June 2013, published in Memorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2157 of 4 September 2013.
There appeared:
The sole shareholder of the Company, MCP-CMC III (Cayman) L.P., an exempted limited partnership existing under
the laws of the Cayman Islands, having its registered office at Elgin Avenue, 190, KY-9005 Grand Cayman, Cayman Islands
(the “Sole Shareholder”),
here represented by Marie-Hélène Emond, with professional address at Luxembourg, by virtue of a proxy given under
private seal.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain
attached to this notarial deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The Sole Shareholder, represented as stated above, has requested the notary to record as follows:
That all the 90,733 (ninety thousand, seven hundred and thirty three) shares of the Company with a nominal value of
USD 1 (one United States Dollars) each, representing the whole share capital of the Company, are represented so that
the meeting can validly decide on all the items of the agenda, of which the Sole Shareholder states as having been duly
informed beforehand.
II. - The agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Waiving of notice right;
2. Change of the representation rules of the Company;
3. Subsequent amendment of article 10 of the articles of association of the Company, in order to reflect the resolution
2. above; and
4. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolutions have been taken:
<i>First resolution:i>
It is resolved that the Sole Shareholder waives its right to notice of the extraordinary general meeting which should
have been sent to it prior to this meeting; the Sole Shareholder acknowledges being sufficiently informed of the agenda
and considers the meeting being validly convened and therefore agrees to deliberate and vote upon all the items of the
agenda. It is resolved further that all the documentation produced to the meeting has been put at the disposal of the Sole
Shareholder within a sufficient period of time in order to allow it to examine carefully each document.
<i>Second resolution:i>
It is resolved to amend the representation rules of the Company such that the Company shall be bound towards third
parties in all matters by (i) the joint signatures of at least 2 (two) managers (any A and/or B managers), including in all
cases the signature of 1 (one) B manager or (ii) the joint or single signatures of any persons to whom such signatory
power has been validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles.
<i>Third resolution:i>
As a consequence of second resolution above, it is resolved to amend article 10 of the articles of association of the
Company, which shall be read as follow:
“ Art. 10. Representation.
10.1. The Company shall be bound towards third parties in all matters by (i) the joint signatures of at least 2 (two)
managers (any A and/or B managers), including in all cases the signature of 1 (one) B manager or (ii) the joint or single
182059
L
U X E M B O U R G
signatures of any persons to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with article 8.2. of
these Articles.”
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which were to be borne by the Company or which would
be charged to it in connection with the present deed, had been estimated at about one thousand four hundred Euros
(EUR 1,400.-).
There being no further business, the meeting is declared closed.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, they signed together with us, the notary, the present original
deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille quatorze, le trentième jour de septembre,
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
S'est réunie
l'Assemblée Générale Extraordinaire de l'associé unique de "MCP III Investment S.à r.l." (la "Société"), une société à
responsabilité limitée luxembourgeoise, ayant son siège social au 7A, rue Robert Stümper, L-2557, Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
154.543, constituée par acte notarié du 6 Juillet 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 7
Septembre 2010, numéro 1828, et modifié pour la dernière fois par un acte notarié du 14 Juin 2013, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations du 4 Septembre 2013, numéro 2157.
Comparait:
L'associé unique de la Société, MCP-CMC III (Cayman) L.P., une société à responsabilité limitée constituée selon le
droit des Iles Caïman, ayant son siège social à Elgin Avenue, 190, KY-9005 Grand Cayman, Iles Caïman (l'“Associé Uni-
que”),
dûment représentée par Marie-Hélène Emond, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une pro-
curation sous seing privé.
Ladite procuration, paraphée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
L'Associé Unique, représenté tel qu'établi ci-dessus, a déclaré et prié le notaire d'acter ce qui suit:
Toutes les 90.733 (quatre-vingt dix mille sept cent trente-trois) parts sociales de la Société avec une valeur nominale
de 1 USD (un dollar américain) chacune, représentant la totalité du capital social de la Société sont représentées, de telle
sorte que l'assemblée peut valablement décider de toutes les questions à l'ordre du jour, dont l'Associé Unique a pré-
alablement été informé.
L'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Renonciation au droit de convocation;
2. Modification des règles de représentation de la Société;
3. Modification subséquente de l'article 10 des statuts de la Société de façon à refléter la résolution 2. ci-dessus; et
4. Divers.
Suite à l'approbation de ce qui précède par l'Associé Unique, les résolutions suivantes ont été adoptées:
<i>Première résolution:i>
Il est décidé que l'Associé Unique renonce à son droit de recevoir la convocation préalable afférente à la présente
assemblée générale; l'Associé Unique reconnaît qu'il a été suffisamment informé de l'ordre du jour et qu'il se considère
avoir été valablement convoqué et en conséquence accepte de délibérer et voter sur tous les points portés à l'ordre du
jour. Il est en outre décidé que toute la documentation produite lors de cette assemblée a été mise à la disposition de
l'Associé Unique dans un laps de temps suffisant afin de lui permettre un examen attentif de chaque document.
<i>Seconde résolution:i>
Il est décidé de modifier les règles de représentation de la Société de sorte que la Société puisse être engagée vis-à-
vis des tiers et à tous égards par (i) les signatures conjointes d'au moins 2 (deux) gérants (gérants A et/ou B), comprenant
182060
L
U X E M B O U R G
dans tous les cas la signature d'1 (un) gérant B ou (ii) les signatures conjointes ou la signature individuelle des personnes
auxquelles ce pouvoir de signature a été valablement délégué conformément à l'article 8.2. des présents Statuts.
<i>Troisième résolution:i>
En conséquence de la seconde résolution qui précède, il est décidé de modifier l'article 10 des statuts actuels de la
Société pour lui donner la teneur suivante:
“ Art. 10. Représentation.
10.1. La Société est engagée vis-à-vis des tiers et à tous égards par (i) les signatures conjointes d'au moins 2 (deux)
gérants (gérants A et/ou B), comprenant dans tous les cas la signature d'1 (un) gérant B ou (ii) les signatures conjointes
ou la signature individuelle des personnes auxquelles ce pouvoir de signature a été valablement délégué conformément
à l'article 8.2. des présents Statuts.
<i>Estimation des coûtsi>
Les coûts, dépenses, frais et charges, quelque soit leur forme, qui devaient être versés par la Société ou qui seraient
mis à sa charge par le présent acte, sont estimés à environ mille quatre cents Euros (EUR 1.400,-).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, au jour indiqué en entête de ce document.
Le document ayant été lu par la personne comparante, elle a signé avec nous, notaire, le présent acte original.
Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, constate que sur demande de la personne comparante, le présent
acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la demande de la personne comparante et en cas de divergence
entre le texte en anglais et le texte en français, la version anglaise prévaudra.
Signé: M.-H. EMOND et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 octobre 2014. Relation: LAC/2014/47148. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 17 novembre 2014.
Référence de publication: 2014177807/130.
(140204076) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2014.
Rollinger Promotion Immobilière S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8126 Bridel, 2, rue Guillaume Stolz.
R.C.S. Luxembourg B 150.458.
L'an deux mille quatorze, le trente octobre.
Par-devant Maître Jean-Paul MEYERS, notaire de résidence à Rambrouch, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société Rollinger Promotion Immobilière S.A., une société
anonyme, établie et ayant son siège social au 66, rue du Dix Octobre à L-7243 Bereldange, (ci-après: «la Société»),
constituée par-devant Maître Émile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg en date du 16 décembre 2009, publié
au Mémorial C numéro 241 du 04 février 2010, et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg,
sous le numéro B150458.
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Wei ZHANG demeurant professionnellement à Hesperange.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Kevin Chang demeurant professionnellement à Hesperange
L'assemblée choisit comme scrutateur Kevin Chang demeurant professionnellement à Hesperange.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun
d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent
se référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Le Président expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
182061
L
U X E M B O U R G
<i>Ordre du jouri>
1. Transfert de siège.
2. Modification afférente de l'article des statuts.
3. Adaptation des statuts afin de permettre que la société puisse être administrée par un Administrateur Unique.
4. Modification afférente des articles des statuts.
5. Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.
C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les
actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend chaque fois à l'unanimité les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de transférer le siège social au 2, rue Guillaume Stolz à
L-8126 Bridel.
<i>Deuxième résolutioni>
Afin de refléter ledit changement, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier l'article
deux, première phrase des statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur suivante:
« Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Kopstal.»
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de prévoir dans les statuts que la société puisse être
administrée par un Administrateur Unique.
<i>Quatrième résolutioni>
Afin de refléter ledit changement, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier les articles
six (6) à 11 (onze) pour leur donner désormais la teneur suivante:
« Art. 6. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont
pas besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que,
à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition
du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre («l'Administrateur Unique) jusqu'à l'assemblée générale
ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.
Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et
la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs
successeurs soient élus.
Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des
actionnaires.
Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance
peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.
Art. 7. Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses mem-
bres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en
charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des action-
naires.
Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans
l'avis de convocation.
Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration;
en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes
à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou
réunions.
Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre
(24) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence
seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment
de chaque administrateur par écrit, par fax ou par courrier électronique ou tout autre moyen de communication similaire.
182062
L
U X E M B O U R G
Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et
un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.
Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit,
par fax, par courrier électronique un autre administrateur comme son mandataire.
Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens
de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques
garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue.
La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion
tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la Société.
Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est
présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas
de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.
Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-
bation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par fax ou par tout autre moyen
de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant
preuve de la décision intervenue.
Art. 8. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en son
absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir
en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d'administration est
composé d'un seul membre, ce dernier signera.
Art. 9. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de
disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément
à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.
Lorsque la Société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
Art. 10. La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion
pourront, conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et
autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions
seront réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose
au conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
avantages quelconques alloués au délégué.
La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.
Art. 11. La Société sera engagée par (i) la signature collective de deux (2) administrateurs ou (ii) la seule signature du
délégué à la gestion journalière ou (iii) la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs
de signature auront été délégués par le conseil d'administration.
Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la société sera engagée par la seule signature de
l'Administrateur Unique.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Helmsange, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire
instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: Zhang, Chang, Jean-Paul Meyers.
Enregistré à Redange/Attert, le 05 novembre 2014. Relation: RED/2014/2298. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Kirsch.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins d'enregistrement auprès du R.C.S.L. et de la
publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Rambrouch, le 17 novembre 2014.
Jean-Paul MEYERS.
Référence de publication: 2014177936/129.
(140204061) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2014.
182063
L
U X E M B O U R G
Ruco S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 33.622.
DISSOLUTION
L'an deux mille quatorze, le sept novembre.
Pardevant Nous Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
A COMPARU:
Monsieur Luc HAESAERTS, avec résidence au 17, boulevard du Larvotto, appartement 8.06, 98000 Monaco (Princi-
pauté de Monaco),
représenté par Monsieur Henri DA CRUZ, employé privé, domicilié professionnellement à Junglinster (Grand-Duché
de Luxembourg),
en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.
Laquelle procuration, après avoir été signée “ne varietur” par le notaire et le mandataire, restera annexée au présent
acte avec lequel elle sera enregistrée.
Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, déclare et requiert le notaire instrumentaire d'acter:
1) Que la société anonyme «RUCO S.A.», ayant son siège à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, R.C.S.
Luxembourg section B numéro 33622, a été constituée par-devant Maître Paul FRIEDERS, alors notaire de résidence à
Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 10 avril 1990, acte publié au Mémorial C numéro 381 du 16
octobre 1990, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par-devant le notaire soussigné en date du 27
juillet 2011, acte publié au Mémorial C numéro 2506 du 18 octobre 2011 (la «Société»).
2) Que le capital de la Société est fixé à quarante-trois mille sept cent cinquante Euros (EUR 43.750,-) représenté par
mille sept cent cinquante (1.750) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune.
3) Que le comparant est l'associé unique de la Société.
4) Que le comparant a décidé de dissoudre et de liquider la Société, qui a interrompu ses activités.
5) Que le comparant se désigne comme liquidateur de la Société et aura pleins pouvoirs d'établir, de signer, d'exécuter
et de délivrer tous actes et documents, de faire toute déclaration et de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour
mettre en exécution les dispositions du présent acte.
6) Que le comparant en sa qualité de liquidateur de la Société déclare de manière irrévocable reprendre tout le passif
présent et futur de la Société dissoute.
7) Que le comparant déclare qu'il reprend tout l'actif de la Société et qu'il s'engagera à régler tout le passif de la Société
indiqué au point 6).
8) Que la liquidation de la Société est à considérer comme définitivement close.
9) Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au commissaire pour l'exécution de leur mandat.
10) Qu'il a été procédé à l'annulation des actions de la Société dissoute.
11) Que les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq ans au moins à l'ancien siège
social à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société,
ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de neuf cent cinquante Euros.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-
meure, ce dernier a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Henri DA CRUZ, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 11 novembre 2014. Relation GRE/2014/4423. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2014177952/49.
(140204014) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2014.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
182064
Bil Manage Invest S.A.
Cameron LUX NOK Sàrl
Capinera S.à r.l.
Diamar
Digital Services XXIV 4 S.C.Sp
Dundeal (International) 13 S.à r.l.
Fusion Funding Luxembourg S.à r.l.
Global Pharm S.à r.l.
Groupe Résidences Pleine Vie S.A.
GT-Sat International S.à r.l.
Gulf SAQR S.à r.l.
Günter Mencher Soparfi S.à r.l.
Halisol Groupe, S.A.
Halva S.A.
Haus + Technik s.àr.l.
HayFin DLF (Europe) Luxco 1 S.à r.l.
HayFin DLF (Europe) Luxco 2 S.à r.l.
HayFin DLF (Europe) Luxco 3 S.à r.l.
Healthcare Real Estate S.à r.l.
Hero S.A.
Highstreet AcquiCo S.à r.l.
Hola Capital S.A.
House Concept S.A.
Hydratec SA
I.D.C.L. S.A.
I.G. Investments S.A.
Immobiliengesellschaft Edward Steichen Building Kirchberg S.A.
Immo Impact S.àr.l.
Industrielle Beteiligung S.A.
Ingersoll-Rand Lux Euro III Financing S.à r.l.
Innovatec-Lubtrading S.A.
Intech S.A.
International Car Rentals S.à r.l.
I.S.C. - International Sponsoring Corporation S.A.
Long Wave S.A.
LU-Invest S.A.
Lutrac Constructions Sàrl
Marsh & McLennan Companies Holdings (Luxembourg) S.à r.l.
MB2s S.A.
MCP III Investment S.à r.l.
MD International S.A.
NPS RE Projects (Luxembourg) Holdings 2 Limited S.à r.l.
NREP Transactions Holding 4 S.à r.l.
NWL Luxembourg S.à r.l.
OCM Luxembourg ROF VI S.à r.l.
Pars Real Estate Foundation Sàrl
Predica Infrastructure S.A.
Professional Care Holding S.à r.l.
RELOG Holding S.à r.l.
Rollinger Promotion Immobilière S.A.
Ruco S.A.
Zamerhof Holding S.A.