logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 3772

8 décembre 2014

SOMMAIRE

Aconit Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

181013

Alliance Data Lux Holdings S.à r.l.  . . . . . . .

181012

ASF II Euro Mountain  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

181012

Athena Consulting S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

181012

Athinea S.A. SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

181012

Atlantic Explorator Company S.A.  . . . . . .

181011

Aurore Invest Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

181013

Azur Clean S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

181011

Barlux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

181011

Bevis Marks Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

181011

DC Harlow Holdco S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

181055

D.R.C. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

181020

Elonis S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

181019

ExIP S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

181025

Fédération Luxembourgeoise de Basket-

ball  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

181048

Filotel S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

181030

FR Prime Holdings III (Luxembourg) S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

181035

GCE Holdco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

181014

GCE Luxco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

181014

Global Pharm Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

181020

Groupe Acticall  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

181014

Halian S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

181031

Harbour LuxCo S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

181013

Junker Claude S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

181054

Kant Capital Fund S.C.A. SICAV-SIF  . . . .

181036

LSREF3 Dutch Investments S.à r.l. . . . . . . .

181021

Lucenda S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

181031

Sagas S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

181010

Salon de Coiffure Millen Isabelle S.à .r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

181010

Sogel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

181016

Stampalux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

181016

Sterren Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

181018

STG IBS Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

181017

Stoneship S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

181019

Studor S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

181017

Symbiose  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

181010

Target Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

181010

Tarpan LuxCo S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

181015

Teak Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

181016

Telewatch International S.A.  . . . . . . . . . . . .

181018

Telewatch International S.A.  . . . . . . . . . . . .

181019

Thermo Fisher Scientific Luxembourg Life

Technologies UK Holding S.à r.l.  . . . . . . .

181018

Thonex France S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

181018

TIM w.e. Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

181010

Tracer S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

181015

Translogistics S. A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

181016

Treid SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

181019

Trinova Select ESP S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

181015

UL S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

181017

UPX International 2 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

181017

181009

L

U X E M B O U R G

Sagas S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3450 Dudelange, 7-9, rue du Commerce.

R.C.S. Luxembourg B 93.673.

Les comptes annuels au 30 JUIN 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Référence de publication: 2014178820/10.
(140204400) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2014.

Salon de Coiffure Millen Isabelle S.à .r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9644 Dahl, 45A, Duerfstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 94.286.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014178821/10.
(140204539) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2014.

Target Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 117.795.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société
Un mandataire

Référence de publication: 2014178876/11.
(140204649) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2014.

TIM w.e. Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 174.727.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour TIM w.e. Holding S.à r.l.
Un mandataire

Référence de publication: 2014178883/11.
(140205179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2014.

Symbiose, Société Anonyme.

Siège social: L-8077 Bertrange, 177, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 41.198.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Symbiose
Société anonyme
FIDUCIAIRE DES P.M.E. SA

Référence de publication: 2014178819/12.
(140204720) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2014.

181010

L

U X E M B O U R G

Azur Clean S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3844 Schifflange, Zone Industrielle Letzebuerger Heck.

R.C.S. Luxembourg B 110.350.

Le bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SCHIFFLANGE, le 4 novembre 2014.

Signature.

Référence de publication: 2014183172/10.
(140206831) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2014.

Atlantic Explorator Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.

R.C.S. Luxembourg B 144.691.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2014183165/10.
(140206404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2014.

Bevis Marks Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 1.681.875,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 161.666.

Le siège social du réviseur d'entreprises agréé, PricewaterhouseCoopers, est désormais le suivant:
2 rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 novembre 2014.

Référence de publication: 2014183182/12.
(140206078) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2014.

Barlux S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 28.300.

<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration en date du 17 novembre 2014

Est nommé administrateur, en remplacement de Monsieur Luc HANSEN, administrateur démissionnaire:
- Monsieur Philippe PONSARD, ingénieur commercial, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle,

L-1653 Luxembourg.

Monsieur Philippe PONSARD terminera le mandat de l'administrateur démissionnaire qui viendra à échéance lors de

l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2014.

Cette cooptation sera soumise à ratification par la prochaine assemblée générale.
Est nommé Président du conseil d'administration:
Monsieur  Reno  Maurizio  TONELLI,  licencié  en  sciences  politiques,  demeurant  professionnellement  au  2,  avenue

Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

La durée de sa présidence sera fonction de celle de son mandat d'administrateur et tout renouvellement, démission

ou révocation de celui-ci entraînera automatiquement et de plein droit le renouvellement ou la cessation de ses fonctions
présidentielles.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 17 novembre 2014.

Référence de publication: 2014183204/22.
(140206136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2014.

181011

L

U X E M B O U R G

Athena Consulting S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38-40, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 76.224.

Les comptes annuels au 31 janvier 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour Athena Consulting S.A.
Fideco S.A.

Référence de publication: 2014183163/12.
(140206782) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2014.

Athinea S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 49.674.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2014183164/13.
(140206653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2014.

Alliance Data Lux Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 22.998.720,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 181.613.

Les comptes annuels consolidés au 31 décembre 2013, de la maison mère "ALLIANCE DATA SYSTEMS CORPORA-

TION" ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 novembre 2014.

<i>Pour Alliance Data Lux Holdings S.à r.l.
Stéphane Hépineuze
<i>Gérant classe B

Référence de publication: 2014183962/14.
(140207404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2014.

ASF II Euro Mountain, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 88.625,00.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 24, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 107.994.

Par résolutions prises en date du 17 novembre 2014, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Nomination de Joan-Sophie Kiener-Wegmann, avec adresse professionnelle au 24, avenue Emile Reuter, L- 2420

Luxembourg, au mandat de gérant, avec effet au 18 novembre 2014 et pour une durée indéterminée;

2. Acceptation de la démission de Jennifer Ferrand, avec adresse professionnelle au 24, avenue Emile Reuter, L- 2420

Luxembourg de son mandat de gérant, avec effet au 18 novembre 2014;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 novembre 2014.

Référence de publication: 2014183159/15.
(140206305) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2014.

181012

L

U X E M B O U R G

Aconit Invest S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 151.094.

Par décision du Conseil d'administration du 20 novembre 2014:
KOFFOUR S.A., société anonyme, R.C.S. Luxembourg B-86086, 42 rue de la Vallée, L -2661 Luxembourg, a désigné

comme représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour son compte au conseil d'admi-
nistration de la société ACONIT INVEST S.A.; Monsieur Eric BREUILLE, 42 rue de la Vallée, L - 2661 Luxembourg, en
remplacement de Monsieur Guy Baumann, démissionnaire.

Luxembourg, le 20 novembre 2014.

<i>Pour: ACONIT INVEST S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme

Référence de publication: 2014183976/17.
(140207535) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2014.

Aurore Invest Fund, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 127.159.

Monsieur Franck Bergeot, administrateur du fonds Aurore Invest Fund S.A.
Nous informe qu'il a changé son lieu de résidence du:
7, Avenue de Brimont
F-78400 CHATOU
À sa nouvelle adresse, valable à partir du 8/10/2014:
1, Avenue Alfred Belmontet
F-92210 SAINT-CLOUD
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21/11/2014.

Certifié conforme et sincère
Finexis S.A.

Référence de publication: 2014183974/18.
(140207956) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2014.

Harbour LuxCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 18.027,88.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2C, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 159.677.

EXTRAIT

Les associés de la Société, par résolutions écrites datées du 24 juin 2014, ont décidé de transférer le siège social de

la Société au 2C, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, avec effet au 15 septembre 2014.

L'associé de la Société, Triton Masterluxco 3 S.à r.l., a également transféré son siège social au 2C, rue Albert Borschette,

L-1246 Luxembourg, avec effet au 15 septembre 2014.

Les adresses professionnelles des gérants Thomas Sonnenberg et Michiel Kramer ont également changé. Lesdits gérants

résident dorénavant professionnellement au 2C, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg.

Le gérant Mats Eklund a également transféré son adresse professionnelle au 9 South Street, 3 

ème

 étage, Londres, W1K

2XA, Royaume-Uni.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Harbour LuxCo S.à r.l.

Référence de publication: 2014184211/19.
(140207272) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2014.

181013

L

U X E M B O U R G

GCE Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: SEK 25.446.750,00.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2C, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 93.011.

EXTRAIT

Les associés de la Société, par résolutions écrites datées du 24 juin 2014 ont décidé de transférer le siège social de la

Société au 2C, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, avec effet au 15 septembre 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour GCE Holdco S.à r.l., (en liquidation)

Référence de publication: 2014184198/12.
(140207726) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2014.

GCE Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: SEK 713.426,00.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2C, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 93.012.

EXTRAIT

Les associés de la Société, par résolutions écrites datées du 24 juin 2014 ont décidé de transférer le siège social de la

Société au 2C, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, avec effet au 15 septembre 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour GCE luxco S.à r.l., (en liquidation)

Référence de publication: 2014184199/13.
(140207725) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2014.

Groupe Acticall, Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 171.740.

Lors de l’Assemblée générale du 27 juin 2014, les résolutions suivantes ont été prises:
1. L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat de tous les administrateurs de la société, à savoir:
- Monsieur BERNARD Guillaume, domicilié 11A Boulevard Joseph II L-1840 Luxembourg. Administrateur de catégorie

C.

- Monsieur UBERTI Laurent, domicilié 56 rue Jeanne d'Arc, F-94160 Saint Mandé (France), Administrateur de catégorie

A.

- Monsieur CAMINO Olivier, domicilié 47 rue du Sergent Bauchat, F-75012 Paris (France), Administrateur de catégorie

A.

- Monsieur DE LACOSTE DE LAVAL Arnaud, domicilié 87Bis rue du Château, F-92600 Asnières (France), Adminis-

trateur de catégorie A.

- Madame TAPIE Séverine, domiciliée 32 Avenue du Grand Veneur, F-78110 Le Vésinet (France), Administrateur de

catégorie B.

- Monsieur DELFOSSE Pascal, domicilié 10 rue du Président Robert Schmann F-59170 Croix (France), Administrateur

de catégorie B.

- Monsieur VIBOUD Jean-Pierre, domicilié 16 rue du Quai F-59800 Lille (France), Administrateur de catégorie B.
2. L'Assemblée Générale décide également de renouveler les mandats des délégués à la gestion journalière, à savoir:
- Monsieur UBERTI Laurent, domicilié 56 rue Jeanne d'ARc, F-94160 Saint Mandé (France).
- Monsieur CAMINO Olivier, domicilié 47 rue du Sergent Bauchat, F-75012 Paris (France).
- Monsieur DE LACOSTE DE LAVAL Arnaud, domicilié 87Bis rue du Château, F-92600 Asnières (France).
Tous les mandats sont renouvelés pour une durée de deux ans, soit jusqu'en 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014184203/29.
(140206908) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2014.

181014

L

U X E M B O U R G

Tarpan LuxCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,06.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2C, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 151.878.

EXTRAIT

Les associés de la Société, par résolutions écrites datées du 24 juin 2014, ont décidé de transférer le siège social de

la Société au 2C, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, avec effet au 15 septembre 2014.

Les adresses professionnelles des gérants Thomas Sonnenberg et Michiel Kramer ont également changé. Lesdits gérants

résident dorénavant professionnellement au 2C, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg.

Le gérant Mats Eklund a également transféré son adresse professionnelle au 9 South Street, 3 

ème

 étage, Londres, W1K

2XA, Royaume-Uni.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Tarpan LuxCo S.à r.l.

Référence de publication: 2014184538/17.
(140207580) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2014.

Trinova Select ESP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 11.000,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 179.295.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé en date du 4 novembre 2014

- La démission de Monsieur Onno Bouwmeister de sa fonction de gérant de la Société a été acceptée par l'associé

unique avec effet immédiat.

- Est nommé gérant de la Société pour une durée indéterminée avec effet immédiat:
* Monsieur Adam Beckett, né le 29 mai 1972 à Londres, Angleterre, avec adresse professionnelle au 40 avenue Mon-

terey, L-2163 Luxembourg.

Luxembourg, le 21 novembre 2014.

Pour extrait conforme
<i>Pour la Société
Un gérant

Référence de publication: 2014184544/18.
(140207410) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2014.

Tracer S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.502,00.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2C, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 157.009.

EXTRAIT

Les associés de la Société, par résolutions écrites datées du 24 juin 2014, ont décidé de transférer le siège social de

la Société au 2C, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, avec effet au 15 septembre 2014.

L'associé Triton Masterluxco 3 S.à r.l. a également transféré son siège social au 2C, rue Albert Borschette, L-1246

Luxembourg, avec effet au 15 septembre 2014.

Les adresses professionnelles des gérants Thomas Sonnenberg et Michiel Kramer ont également changé. Lesdits gérants

résident dorénavant professionnellement au 2C, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg.

Le gérant Mats Eklund a également transféré son adresse professionnelle au 9 South Street, 3 

ème

 étage, Londres, W1K

2XA, Royaume-Uni.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Tracer S.à r.l.

Référence de publication: 2014184543/19.
(140207727) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2014.

181015

L

U X E M B O U R G

Translogistics S. A., Société Anonyme.

Siège social: L-9990 Weiswampach, 2, Duarrefstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 106.869.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, le 21 novembre 2014.

Référence de publication: 2014184553/10.
(140207525) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2014.

Sogel, Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 7, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 5.282.

Les statuts coordonnés de la société, rédigés en suite de l’assemblée générale du 07.11.2014, ont été déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Capellen, le 21.11.2014.

Référence de publication: 2014184522/11.
(140207375) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2014.

Stampalux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 61.666.

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire de la Société tenue en date du 20 novembre 2014 que:
- La démission de Monsieur Olivier LIEGEOIS, administrateur de la Société, a été acceptée avec effet au 29 août 2014;
- La personne suivante a été nommée en tant qu'administrateur de la Société, avec effet au 29 août 2014 et ce jusqu'à

l'assemblée générale qui statuera sur les comptes clos au 31 décembre 2016:

* Madame Sandrine BISARO née le 28 juin 1969 à Metz, France, résidant professionnellement au 16, avenue Pasteur

L-2310 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 novembre 2014.

Référence de publication: 2014184525/16.
(140207112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2014.

Teak Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2C, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 134.327.

EXTRAIT

L'assemblée générale extraordinaire de la Société tenue le 8 juillet 2014 a décidé de transférer le siège social de la

Société au 2C, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, avec effet au 15 septembre 2014.

Les adresses professionnelles des administrateurs Heiko Dimmerling, Thomas Sonnenberg, Michiel Kramer et Antonis

Tzanetis ont également changé. Lesdits administrateurs résident dorénavant professionnellement au 2C, rue Albert Bor-
schette, L-1246 Luxembourg.

L'administrateur Mats Eklund a également transféré son adresse professionnelle au 9 South Street, 3 

ème

 étage, Londres,

W1K 2XA, Royaume-Uni.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Teak Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2014184539/17.
(140207728) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2014.

181016

L

U X E M B O U R G

Studor S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon Ier.

R.C.S. Luxembourg B 81.345.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014183844/9.
(140206610) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2014.

STG IBS Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 162.319.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour STG IBS Holding S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2014183842/11.
(140206761) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2014.

UPX International 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3364 Leudelange, 1, rue de la Poudrerie.

R.C.S. Luxembourg B 167.078.

Suite à l'assemblée générale extraordinaire du 3 novembre 2014, il convient de modifier l'adresse de l'associé UPX

International S.à r.l.

La nouvelle adresse de cet associé est, avec effet au 20 octobre 2014:
1 rue de la Poudrerie à L-3364 Leudelange.

Luxembourg, le 17 novembre 2014.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014183892/15.
(140206160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2014.

UL S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 100.000,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 161.535.

<i>Extrait de l'acte de fusion daté du 24 septembre 2014

En vertu de la fusion datée du 24 SEPTEMBRE 2014, l'actionnaire unique de la société, WHM Holdings LLC, ayant son

siège social au 160, Greentree Drive, 19904 Dover, Delaware, Etats-Unis, enregistré auprès du Delaware Trade and
Companies' Register sous le numéro 110324163,

A été absorbée par son manager unique, UL inc., une corporation constituée et existante sous les lois de l'Etat de

Delaware, ayant son siège social au 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801 Etats-Unis, enregistré auprès du
Delaware Trade and Companies' Register sous le numéro 4570442.

Suite à cette fusion, il est porté à la connaissance des tiers que l'actionnaire unique de la société est à présent UL Inc.

Luxembourg, le 19 Novembre 2014.

Xavier de Cillia
<i>Gérant B

Référence de publication: 2014183891/19.
(140205669) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2014.

181017

L

U X E M B O U R G

Thonex France S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R.C.S. Luxembourg B 177.085.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014183874/9.
(140206665) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2014.

Sterren Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 111.849.

Les comptes annuels au 30 juin 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour STERREN INVESTMENTS S.A.
Un mandataire

Référence de publication: 2014183840/11.
(140206636) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2014.

Telewatch International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 63.415.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 12 novembre 2014 que:
- Gestman S.A. a démissionné de son poste de commissaire.
- A été nommée au poste de Commissaire en remplacement du commissaire démissionnaire:
* Gestal Sàrl, immatriculée au RCS de Luxembourg sous le numéro B 184722 avec siège social au 23, rue Aldringen -

L-1118 Luxembourg.

- Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale annuelle de 2015.

Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2014183866/16.
(140206623) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2014.

Thermo Fisher Scientific Luxembourg Life Technologies UK Holding S.à r.l., Société à responsabilité

limitée.

Capital social: USD 16.100,00.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 190.804.

Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales conclu en date du 8 octobre 2014, que l'associé unique de la Société,

Monsieur Pierre Metzler, a cédé l'intégralité des parts sociales de la Société, soit 16.100 parts sociales à la société Invi-
trogen Holdings Inc., une société, constituée selon le droit de l'Etat du Delaware (Etats-Unis d'Amérique), ayant son siège
social à 1675, South State Street, STE B Dover, Delaware 19901, Etats-Unis d'Amérique, enregistrée au registre de l'Etat
du Delaware sous le numéro 3769537.

Suite au transfert des parts sociales, dont la date effective est fixée au 26 septembre 2014, Invitrogen Holdings Inc.

détient 16.100 parts sociales de la Société, représentant l'intégralité du capital social de la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 novembre 2014.

Référence de publication: 2014183858/18.
(140206536) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2014.

181018

L

U X E M B O U R G

Telewatch International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 63.415.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014183865/10.
(140206605) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2014.

Stoneship S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 181.397.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 novembre 2014.

Léonie Grethen.

Référence de publication: 2014183843/10.
(140207038) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2014.

Elonis S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 182.164.

Il est porté à la connaissance de qui de droit que l'Associé unique, à savoir Catalyst Citygate LLP, ayant son siège social

au 18 

th

 Floor, 33 Cavendish Square, W1G OPW Londres, Royaume-Uni, détentrice de 100 parts sociales de Elonis S.à

r.l., a cédé la totalité de ses parts en date du 29 octobre 2014 à Catalyst European Property Fund II LP ayant son siège
social au 18 

th

 Floor, 33 Cavendish Square, W1G OPW Londres, Royaume-Uni.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2014184136/14.
(140207092) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2014.

Treid SA, Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 101.021.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 6 novembre 2014, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième section,

siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, la dissolution et la liquidation de la société:

- Société anonyme TREID SA, dont le siège social à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau, a été dénonce en date du

14 janvier 2011, (N° R.C.S. B 101021)

Le même jugement a nommé Juge-Commissaire Madame Anita LECUIT, juge au tribunal d'Arrondissement de et à

Luxembourg, et désigné comme liquidateur Maître Emilie MELLINGER, avocat, demeurant à L-4170 Esch-sur-Alzette, 24,
Bd Kennedy.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 27 novembre 2014 au greffe du Tribunal

de commerce.

Pour extrait conforme
Emilie MELLINGER
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2014183886/20.
(140206970) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2014.

181019

L

U X E M B O U R G

Global Pharm Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 161.892.

<i>Rectificatif L-140204892

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 novembre 2014.

Référence de publication: 2014179188/11.
(140205806) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2014.

D.R.C. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 2, am Hock.

R.C.S. Luxembourg B 83.889.

L'an deux mille quatorze, le vingt-neuf octobre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie

l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme “D.R.C. S.A.”, (la "Société"), établie et

ayant son siège social 2, Am Hock, L-9991 Weiswampach, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg, section B, sous le numéro 83.889, ayant été constituée suivant acte notarié en date du 21 septembre 2001, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 240 du 12 février 2002. Les statuts ont été modifiés en
dernier lieu suivant acte notarié en date 25 juin 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
2374 du 26 septembre 2013.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Céline PEIFFER, employée, demeurant professionnellement à

Luxembourg,

(ci-après le “Président”),
qui désigne comme secrétaire Monsieur Gérard DARDENNE, employé, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg qui est aussi choisi comme scrutateur.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter que:
I. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires
présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Restera pareillement annexée au présent acte la procuration des actionnaires représentés, après avoir été signée “ne

varietur” par les comparants et le notaire instrumentant.

II. Tel qu’il résulte de la liste de présence, la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est réguliè-

rement constituée et peut délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

III. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Augmentation du capital de la Société à concurrence de dix-huit millions sept cent soixante-quinze mille euros (EUR

18.775.000), afin de le porter de son montant actuel de un million deux cent vingt-cinq mille euros (EUR 1.225.000) à un
montant de vingt millions d’euros (EUR 20.000.000) par apport en numéraire, pour un montant de dix-huit millions sept
cent soixante-quinze mille euros (EUR 18.775.000), par l’émission de dix-huit mille sept cent soixante-quinze (18.775)
actions nouvelles d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000) chacune;

2. Souscription aux actions nouvelles, renonciation au droit préférentiel de souscription et libération des apports;
3. Modification de l’article 5, alinéa 1 des statuts, suite aux résolutions précédentes.
Après délibération, l’assemblée générale prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital de la Société à concurrence de dix-huit millions sept cent soixante-

quinze mille euros (EUR 18.775.000) afin de le porter de son montant actuel d’un million deux cent vingt-cinq mille euros
(EUR 1.225.000) à un montant de vingt millions d’euros (EUR 20.000.000), par l’émission de dix-huit mille sept cent
soixante-quinze (18.775) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000) chacune.

L’assemblée admet à la souscription des dix-huit mille sept cent soixante-quinze (18.775) nouvelles actions, la société

«Duvel Moortgat NV», une société anonyme constituée et organisée selon le droit belge, ayant son siège social à Breen-
donkdorp 58, 2870 Puurs, enregistrée sous le numéro (Registre des personnes morales de Mechelen) 0400.764.903.

181020

L

U X E M B O U R G

<i>Souscription et libération

«Duvel Moortgat NV», prénommée, ici représentée par Madame Céline PEIFFER, prénommée, en vertu d’une pro-

curation  sous  seing privé,  ci-annexée  déclare  souscrire  aux  dix-huit mille  sept cent  soixante-quinze (18.775)  actions
nouvelles d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000) chacune et déclare les libérer intégralement par apport en
numéraire d’un montant de dix-huit millions sept cent soixante-quinze mille euros (EUR 18.775.000).

L’autre actionnaire a renoncé à son droit de souscription préférentiel.
La somme de dix-huit millions sept cent soixante-quinze mille euros (EUR 18.775.000) se trouve dès à présent à la

libre disposition de la Société ce dont il a été justifié au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution précédente, l’assemblée décide de modifier l’article 5, alinéa 1 des statuts afin de lui conférer la

teneur suivante:

« Art. 5. alinéa 1. Le capital social est fixé à vingt millions d’euros (EUR 20.000.000) représenté par vingt mille (20.000)

actions de mille euros (EUR 1.000) chacune.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à la somme de six mille euros.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, ès-qualité qu'il agit, connu du

notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, ladite mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: C. PEIFFER, G. DARDENNE, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 04 novembre 2014. Relation: EAC/2014/14789. Reçu soixante-quinze Euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur ff. (signé): Monique HALSDORF.

Référence de publication: 2014176799/70.
(140202767) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2014.

LSREF3 Dutch Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 154.412.499,00.

Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romains.

R.C.S. Luxembourg B 191.119.

In the year two thousand and fourteen, on the seventh day of November,
Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

LSREF3 Dutch Holdings S.à r.l. (formerly named LSREF3 Lux Investments VII S.à r.l.), a private limited liability company

(société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having
its registered office at Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Lu-
xembourg, with a share capital of EUR 1,723,500.- and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
(Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) (the “RCS”) under number B 188000 (the “Shareholder”),

hereby represented by Mrs. Valérie Fagnant, employee, with professional address in Bertrange, by virtue of a power

of attorney, given in Bertrange on 6 November 2014,

which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

The Shareholder, represented as stated above, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary

to act that it represents the entire share capital of LSREF3 Dutch Investments S.à r.l., a Luxembourg private limited liability
company securitization vehicle (société à responsabilité limitée - société de titrisation), having its registered office at
Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, with a share
capital of EUR 130,685,227.-, registered with the RCS under number B 191119 and incorporated pursuant to a deed of
the undersigned notary dated 13 October 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the
“Mémorial”) on 28 October 2014 under number 3126, which articles of incorporation have been amended for the last
time on 30 October 2014 by a deed of the undersigned notary, not yet published in the Mémorial (the “Company”).

The appearing party, through its proxyholder, declared and requested the undersigned notary to state that:
A. The entire issued share capital represented by one hundred thirty million six hundred eighty-five thousand two

hundred twenty-seven (130,685,227) shares is held by the Shareholder.

181021

L

U X E M B O U R G

B. The Shareholder is represented by proxy so that all shares in issue in the Company are represented at this ex-

traordinary decision of the Shareholder so that the decisions can be validly taken on all the items of the below agenda.

C. The agenda of the meeting is as follows:

<i>Agenda

1) Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 23,727,272.- (twenty-three million seven hundred

twenty-seven thousand two hundred seventy-two euro) in order to increase the current capital from its current amount
of EUR 130,685,227.- (one hundred thirty million six hundred eighty-five thousand two hundred twenty-seven euro) to
an amount of EUR 154,412,499.- (one hundred fifty-four million four hundred twelve thousand four hundred ninety-nine
euro) by the creation and issue of 23,727,272 (twenty-three million seven hundred twenty-seven thousand two hundred
seventy-two) new ordinary shares, having a nominal value of EUR 1.- (one euro) each (the “New Shares”); subscription
and payment of the New Shares by the Shareholder by a contribution in cash for a total amount of EUR 26,100,000.-
(twenty-six million one hundred thousand euro) which shall be allocated (a) to the share capital of the Company for an
amount of EUR 23,727,272 (twenty-three million seven hundred twenty-seven thousand two hundred seventy-two euro),
(b) to the legal reserve for an amount of EUR 2,372,727.20 (two million three hundred seventy-two thousand seven
hundred twenty-seven euro and twenty cents) and (c) to the share premium account for an amount of EUR 0.80 (zero
euro and eighty cents).

2) As a consequence, amendment of the first sentence of the first paragraph of article 5 of the Company’s articles of

association as follows to reflect the share capital increase proposed above:

“ Art. 5. Share capital. The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 154,412,499.- (one hundred fifty-four

million four hundred twelve thousand four hundred ninety-nine euro), represented by 154,412,499.- (one hundred fifty-
four million four hundred twelve thousand four hundred ninety-nine) ordinary shares having a nominal value of EUR 1.-
(one euro) each.”

3) Amendment of the share register of the Company in order to reflect the changes proposed above with power and

authority to any manager of the Company and/or any employee of Lone Star Capital Investments S.à r.l., to proceed,
under his/her sole signature, on behalf of the Company (i) to the registration of the New Shares in the share register of
the Company and (ii) to the performance of any formalities in connection therewith.

This having been declared, the Shareholder, represented as stated above, then asked the undersigned notary to record

its resolutions as follows:

<i>First resolution

The Shareholder resolved to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 23,727,272.- (twenty-

three million seven hundred twenty-seven thousand two hundred seventy-two euro)

so as to raise it from its current amount of EUR 130,685,227.- (one hundred thirty million six hundred eighty-five

thousand  two  hundred  twenty-seven  euro)  to  an  amount  of  EUR  154,412,499.-  (one  hundred  fifty-four  million  four
hundred twelve thousand four hundred ninety-nine euro)

by the creation and issue of 23,727,272.- (twenty-three million seven hundred twenty-seven thousand two hundred

seventy-two) New Shares, having a nominal value of EUR 1.- (one euro) each, in consideration of a contribution in cash
by the Shareholder of an aggregate amount of EUR 26,100,000.- (twenty-six million one hundred thousand euro) allocated
as follows.

<i>Subscription - Payment

The Shareholder, represented as stated above, declared to subscribe for 23,727,272.- (twenty-three million seven

hundred twenty-seven thousand two hundred seventy-two) New Shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) per
share and to make payment in full for such New Shares by a contribution in cash for a total amount of EUR 26,100,000.-
(twenty-six million one hundred thousand euro) which is allocated (a) to the share capital of the Company for an amount
of EUR 23,727,272.- (twenty-three million seven hundred twenty-seven thousand two hundred seventy-two euro), (b)
to the legal reserve for an amount of EUR 2,372,727.20 (two million three hundred seventy-two thousand seven hundred
twenty-seven euro and twenty cents) and (c) to the share premium account for an amount of EUR 0.80 (zero euro and
eighty cents).

All the 23,727,272.- (twenty-three million seven hundred twenty-seven thousand two hundred seventy-two) New

Shares issued are therefore fully subscribed and paid up in cash by the Shareholder so that the amount of EUR 26,100,000.-
(twenty-six million one hundred thousand euro) is at the free disposal of the Company as it has been proved to the
undersigned notary who expressly bears witness to it.

As a consequence of the above-resolved share capital increase, the Shareholder now holds 154,412,499.- (one hundred

fifty-four million four hundred twelve thousand four hundred ninety-nine euro) ordinary shares of the Company.

<i>Second resolution

As a consequence of the first resolution, the Shareholder resolved to amend the first sentence of the first paragraph

of article 5 of the Company’s articles of association, which English version shall be henceforth reworded as follows:

181022

L

U X E M B O U R G

“ Art. 5. Share capital (first sentence). The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 154,412,499.- (one

hundred fifty-four million four hundred twelve thousand four hundred ninety-nine euro), represented by 154,412,499
(one hundred fifty-four million four hundred twelve thousand four hundred ninety-nine) ordinary shares having a nominal
value of EUR 1.- (one euro) each.”

<i>Third resolution

The Shareholder resolved to amend the share register of the Company in order to reflect the changes resolved above

and hereby empower and authorise any manager of the Company and/or any employee of Lone Star Capital Investments
S.à r.l., to proceed, under his/her sole signature, on behalf of the Company (i) to the registration of the New Shares in
the share register of the Company and (ii) to any formalities in connection therewith.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are

estimated at EUR 6500.

Nothing else being on the agenda, the meeting is closed.

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg on the day indicated above.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing

party the present deed is worded in English, followed by a French translation. At the request of the appearing party and
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the proxyholder of the appearing party, said person appearing signed

with Us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le sept novembre,
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

A COMPARU:

LSREF3 Dutch Holdings S.à r.l. (anciennement denommée LSREF3 Lux Investments VII S.à r.l.), une société à respon-

sabilité limitée constituée et existant sous le droit luxembourgeois, ayant son siège social à l’Atrium Business Park-Vitrum,
33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duché de Luxembourg, ayant un capital social de EUR 1.723.500,- et
immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg (le «RCS») sous le numéro B 188000 (l’
«Associé»),

ici  représentée  par  Mme  Valérie  Fagnant,  salariée,  ayant  son  adresse  professionnelle  à  Bertrange,  en  vertu  d'une

procuration donnée à Bertrange, le 6 novembre 2014.

Ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné,

restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

L’Associé, représenté comme indiqué ci-avant, a requis le notaire instrumentaire de prendre acte de ce qu'il représente

la totalité du capital social de LSREF3 Dutch Investments S.à r.l., société à responsabilité limitée - société de titrisation
au capital de EUR 130.685.227,-immatriculée auprès du RCS sous le numéro B 191119, ayant son siège social à l’Atrium
Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duché de Luxembourg, et constituée selon un
acte du notaire instrumentaire, daté du 13 octobre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le
«Mémorial») en date du 28 octobre 2014 sous le numéro 3126, lesquels statuts ont été modifiés pour la dernière fois en
date du 30 octobre 2014 par un acte du notaire instrumentaire, non encore publié au Mémorial (la «Société»).

La partie comparante, par son mandataire, a déclaré et requis le notaire d’acter ce qui suit:
A. La totalité du capital social, représentée par cent trente millions six cent quatre-vingt-cinq mille deux cent vingt-

sept (130.685.227) parts sociales, est détenu par l’Associé.

B. L’Associé est représenté en vertu d’une procuration de sorte que toutes les parts sociales émises par la Société

sont représentées à cette décision extraordinaire de l’Associé et toutes les décisions peuvent être valablement prises sur
tous les points de l’ordre du jour ci-après.

C. L’ordre du jour est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. Augmentation du capital social de la Société par un montant de EUR 23.727.272,- (vingt-trois millions sept cent

vingt-sept  mille  deux  cent  soixante-douze  euros)  afin  d’augmenter  le  capital  social  de  son  montant  actuel  de  EUR
130.685.227,- (cent trente millions six cent quatre-vingt-cinq mille deux cent vingt-sept euros) à un montant de EUR
154.412.499,- (cent cinquante quatre million quatre cent douze mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf euros) par voie
de création et d'émission de 23.727.272 (vingt-trois millions sept cent vingt-sept mille deux cent soixante-douze) nouvelles
parts  sociales  ordinaires,  ayant  une  valeur  nominale  de  EUR  1,-  (un  euro)  chacune  (les  «Nouvelles  Parts  Sociales»);
souscription et paiement des Nouvelles Parts Sociales par l’Associé par un apport en numéraire pour un montant total
de EUR 26.100.000,- (vingt six millions cent mille euros) qui sera alloué (a) au capital social de la Société pour un montant

181023

L

U X E M B O U R G

de EUR 23.727.272,- (vingt-trois millions sept cent vingt-sept mille deux cent soixante-douze euros), (b) à la réserve légale
pour un montant de EUR 2.372.727,20 (deux millions trois cent soixante-douze mille sept cent vingt-sept euros et vingt
centimes) et (c) au compte de prime d’émission pour un montant de EUR 0,80 (zéro euro et quatre-vingt centimes);

2. En conséquence, modification de la première phrase du premier paragraphe de l’article 5, des statuts de la Société

comme suit afin de refléter l’augmentation de capital proposée ci-dessus:

« Art. 5. Capital Social. Le capital social est fixé à EUR 154.412.499,- (cent cinquante-quatre millions quatre cent douze

mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf euros) représenté par 154.412.499 (cent cinquante-quatre millions quatre cent
douze  mille  quatre  cent  quatre-vingt-dix-neuf)  parts  sociales  ordinaires  d’une  valeur  nominale  de  EUR  1,-  (un  euro)
chacune.»

3. Modification du registre de parts sociales de la Société de façon à refléter les changements proposés ci-dessus avec

pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société et/ou à tout employé de Lone Star Capital Investments S.à r.l., afin
d’effectuer, par sa seule signature, pour le compte de la Société, (i) l’inscription des Nouvelles Parts Sociales dans le
registre de parts sociales de la Société et (ii) la réalisation de toute formalité en relation avec ce point.

Ceci ayant été déclaré, l’Associé représenté comme indiqué ci avant, a requis le notaire soussigné de prendre acte des

résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Associé décide d’augmenter le capital social de la Société par un montant de EUR 23.727.272,- (vingt-trois millions

sept cent vingt-sept mille deux cent soixante-douze euros)

afin de le porter de son montant actuel de EUR 130.685.227,- (cent trente millions six cent quatre-vingt-cinq mille

deux cent vingt-sept euros) à un montant de EUR 154.412.499,- (cent cinquante-quatre millions quatre cent douze mille
quatre cent quatre-vingt-dix-neuf euros)

par la création et l’émission de 23.727.272 (vingt-trois millions sept cent vingt-sept mille deux cent soixante-douze)

Nouvelles  Parts  Sociales,  ayant  une  valeur  nominale  de  EUR  1,-  (un  euro)  chacune,  en  contrepartie  d’un  apport  en
numéraire de l’Associé d’un montant total de EUR 26.100.000,- (vingt-six millions et cent mille euros).

<i>Souscription - Paiement

L’Associé, représenté comme indiqué ci-avant, a déclaré souscrire 23.727.272 (vingt-trois millions sept cent vingt-sept

mille deux cent soixante-douze) Nouvelles Parts Sociales d'une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) par part sociale

et libérer intégralement ces Nouvelles Parts Sociales souscrites par un apport en numéraire pour un montant total de

EUR 26.100.000,- (vingt-six millions et cent mille euros) qui est alloué (a) au capital social de la Société pour un montant
de EUR 23.727.272 (vingt-trois millions sept cent vingt-sept mille deux cent soixante-douze euros), (b) à la réserve légale
pour un montant de EUR 2.372.727,20 (deux millions trois cent soixante-douze mille sept cent vingt-sept euros et vingt
centimes) et (c) au compte de prime d’émission pour un montant de EUR 0.80 (zéro euro et quatre-vingt centimes).

L'ensemble des 23.727.272 (vingt-trois millions sept cent vingt-sept mille deux cent soixante-douze) Nouvelles Parts

Sociales émises sont donc intégralement souscrites et libérées en numéraire par l’Associé, de sorte que la somme de
EUR 26.100.000,- (vingt-six millions cent mille euros) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au
notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Suite à l’augmentation de capital décidée ci-dessus, l’Associé détient maintenant 154.412.499 (cent cinquante-quatre

millions quatre cent douze mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf) parts sociales ordinaires de la Société.

<i>Deuxième résolution

Suite à la première résolution, l’Associé décide de modifier la première phrase du premier paragraphe de l’article 5

des statuts de la Société, dont la version française aura désormais la teneur suivante:

« Art. 5. Capital Social. Le capital social est fixé à EUR 154.412.499 (cent cinquante-quatre millions quatre cent douze

mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf euros) représenté par 154.412.499 (cent cinquante-quatre millions quatre cent
douze  mille  quatre  cent  quatre-vingt-dix-neuf)  parts  sociales  ordinaires  d’une  valeur  nominale  de  EUR  1,-  (un  euro)
chacune.»

<i>Troisième résolution

L'Associé décide de modifier le registre de parts sociales de la Société afin de refléter les changements effectués ci-

dessus  et  mandate  et  autorise  par  la  présente  tout  gérant  de  la  Société  et/ou  tout  employé  de  Lone  Star  Capital
Investments S.à r.l., afin d'effectuer, par sa seule signature, pour le compte de la Société, (i) l’inscription de l’émission des
Nouvelles Parts Sociales dans le registre de parts sociales de la Société ainsi que (ii) la réalisation de toute formalité en
relation avec ce point.

<i>Frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payables par la Société en raison du présent acte sont évalués

approximativement à EUR 6500.

181024

L

U X E M B O U R G

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, l’assemblée est clôturée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que la partie comparante l’a requis de documenter le

présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête de la partie comparante, en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé avec Nous notaire

la présente minute.

Signé: V. Fagnant et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 11 novembre 2014. LAC/2014/52847. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).

<i>Le Receveur ff. (signé): Carole Frising.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 novembre 2014.

Référence de publication: 2014177011/209.
(140202862) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2014.

ExIP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6665 Herborn, 19, Haaptstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 192.015.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendvierzehn, am 18. November
Ist vor Maître Blanche MOUTRIER, Notarin mit Amtssitz in Esch-sur-Alzette,

Erschienen:

Frau Sarina SOLEIMANI, geboren zu Téhéran (Iran) am 18. September 1983, wohnhaft in L-6665 Herborn, 19, Haapts-

trooss,

Welche Komparentin, die instrumentierende Notarin ersucht, die Satzung einer von ihr zu gründenden Gesellschaft

mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Zwischen der vorbenannten Partei und all denjenigen, die zu einem späteren Zeitpunkt Inhaber der nachstehend

geschaffenen  Gesellschaftsanteile  werden  sollten,  wird  eine  Gesellschaft  mit  beschränkter  Haftung,  luxemburgischen
Rechts gegründet, welche durch die vorliegende Satzung und die einschlägige luxemburgische Gesetzgebung geregelt wird.

Art. 2. Die Bezeichnung der Gesellschaft lautet:
„ExIP S.à r.l.“

Art. 3. Der Gesellschaftssitz wird in Herborn festgelegt.
Er kann an jeden anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden, dies durch einfachen Beschluss des oder

der Geschäftsführer(s), welche sämtliche Befugnisse besitzen, um den vorliegenden Artikel anzupassen.

Art. 4. Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer gegründet.
Jeder Gesellschafter kann seine Beteiligung an der Gesellschaft kündigen. Die Kündigung erfolgt per Einschreiben,

welches mit sechsmonatiger Vorankündigung an die Gesellschafter und Geschäftsführer zu senden ist. Der Gesellschafter,
der aus der Gesellschaft auszutreten beabsichtigt, hat sich nach den Bestimmungen aus Artikel zehn der Satzung zu richten.

Unbeschadet des Vorstehenden kann die Gesellschaft vorzeitig durch einen Beschluss, der mit einfacher Mehrheit der

das Gesellschaftskapital vertretenden Anteile gefasst wurde, aufgelöst werden.

Art. 5. Zweck der Gesellschaft ist jegliche Patente, Lizenzen und Warenzeichen und sonstige mit diesen Patenten,

Lizenzen und Warenzeichen verbundenen oder diese ergänzenden Rechte zu erwerben und zu verwerten.

Außerdem, Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung in jedweder Form an luxemburgischen oder ausländischen Un-

ternehmen und jede sonstige Anlageform, der Erwerb mittels Kauf, Zeichnung oder auf jede sonstige Weise, sowie die
Veräußerung mittels Verkauf, Tausch oder auf andere Weise von Wertpapieren, Schuldverschreibungen, Forderungen,
Schuldscheinen und sonstigen Werten jeder Art, und die Verwaltung, Kontrolle und Entwicklung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann sich, sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland, an der Gründung und Ent-

wicklung  jeglicher  Finanz-,  Industrie-  und  Handelsunternehmen  beteiligen  und  diesen  ihre  Unterstützung  durch  die
Bewilligung von Darlehen, Garantien oder auf jede sonstige Weise gewähren.

Die Gesellschaft kann in jeglicher Form, verzinslich oder unverzinslich, Darlehen bewilligen und Anleihen aufnehmen,

und die Begebung von Schuldverschreibungen an verschiedene Gesellschaften (ob Tochtergesellschaften oder nicht) vor-
nehmen.

181025

L

U X E M B O U R G

Die Gesellschaft kann jegliche Patente, Lizenzen und Warenzeichen und sonstige mit diesen Patenten, Lizenzen und

Warenzeichen verbundenen oder diese ergänzenden Rechte erwerben und verwerten.

Die Gesellschaft kann jegliche direkt oder indirekt mit ihrem Gesellschaftszweck zusammenhängenden Mobiliar-, Fi-

nanz-, Industrie- und Handelsgeschäfte tätigen und eine der Öffentlichkeit zugängliche Handelsniederlassung führen.

Zweck der Gesellschaft ist der Kauf, der Verkauf, die Vermietung, die Verwaltung und die Verwertung in jedweder

Form von Immobilien sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland, sowie jegliche direkt oder indirekt
damit verbundenen Handels-, Finanz-, Immobilien- und Mobiliargeschäfte.

Ganz allgemein kann die Gesellschaft jegliche Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen treffen und sämtliche Geschäfte

tätigen, die sie für die Erfüllung oder die Entwicklung ihres Gesellschaftszwecks für nützlich erachtet.

Die Gesellschaft hat ferner zum Zweck, Vergütungen und Entgelte von den Konzerngesellschaften zu vereinnahmen,

sowie die Verwaltung und Geschäftsführung dieser Konzerngesellschaften, denen sie namentlich jegliche strategische,
verwaltungstechnische oder kommerzielle Unterstützung gewähren kann, zu übernehmen.

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- €), verbrieft durch einhundertfün-

fundzwanzig (125) Gesellschaftsanteile von je einhundert Euro (100,- €).

Art. 7. Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt zu einem anteiligen Bruchteil am Gesellschaftsvermögen und -gewinn.

Art. 8. Die ungeteilten Mitinhaber von Gesellschaftsanteilen, die bloßen Eigentümer und die Nießbraucher werden der

Gesellschaft gegenüber durch ein und dieselbe Person vertreten, die im vornhinein durch einen Beschluss der Gesell-
schafter, welcher mit einfacher Mehrheit der das Gesellschaftskapital vertretenden Anteile gefasst wurde, gebilligt wurde.
Diese Billigung darf lediglich aus berechtigten Gründen vorenthalten werden.

Art. 9. Die Gesellschaftsanteile sind mortis causa frei abtretbar, selbst durch letztwillige Verfügung, sofern diese Über-

tragung in direkter Linie oder an den überlebenden Ehepartner erfolgt. Sonstige Begünstigte müssen durch einstimmigen
Beschluss der überlebenden Gesellschafter gebilligt werden. Im Falle der Verweigerung muss der Begünstigte gemäß den
Bestimmungen aus Artikel zehn der Satzung vorgehen, mit Ausnahme des letzten Absatzes, und ist an das Ergebnis des
Sachverständigengutachtens gebunden. Sollte keiner der Gesellschafter bereit sein, die Gesellschaftsanteile zum festge-
setzten Preis zu erwerben, wird der Begünstigte von Rechts wegen Gesellschafter.

Art. 10.
a) Beabsichtigt ein Gesellschafter, seine Gesellschaftsanteile ganz oder teilweise abzutreten, sowie in den in den Artikeln

vier und neun vorgesehenen Fällen, muss er sie seinen Mitgesellschaftern anteilig zu deren Beteiligung an der Gesellschaft
anbieten.

b) Im Falle einer andauernden Uneinigkeit der Gesellschafter über den entsprechenden Preis und nach Ablauf einer

zweiwöchigen Frist, müssen der oder die Gesellschafter, die ihre Anteile abtreten möchten, und der oder die Gesell-
schafter, die diese zu erwerben beabsichtigen, jeder einen Sachverständigen damit beauftragen, den Abtretungswert unter
Zugrundelegung des Verkehrswertes der Anteile festzusetzen.

c) Die Gesellschaft übermittelt allen Gesellschaftern das Ergebnis des Sachverständigengutachtens per Einschreiben

und fordert sie auf, innerhalb einer vierwöchigen Frist mitzuteilen, ob sie bereit sind, die Anteile zum festgesetzten Preis
zu erwerben oder abzutreten. Bekunden mehrere Gesellschafter ihre Absicht, die zum Verkauf angebotenen Anteile zu
erwerben, so werden diese den interessierten Gesellschaftern anteilig zu ihrer Beteiligung an der Gesellschaft angeboten.
Das Schweigen der Gesellschafter während der vorerwähnten vierwöchigen Frist gilt als Ablehnung.

d) In diesem Falle kann der abtretende Gesellschafter die Anteile Nichtgesellschaftern anbieten, wobei den anderen

Gesellschaftern ein Vorkaufsrecht im Verhältnis zu ihrer jeweiligen Beteiligung während einer zweiwöchigen Frist vor-
behalten bleibt, gerechnet ab Datum der Mitteilung der mit Drittinteressenten getroffenen Vereinbarung und gemäß den
entsprechenden Bedingungen. Artikel 189 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften wird durch die Artikel neun und
zehn der vorliegenden Satzung ersetzt.

Art. 11. Die Gesellschaft kann durch einen Beschluss der Hauptversammlung, der mit der Mehrheit der das Gesell-

schaftskapital vertretenden Anteile gefasst wurde, ihre eigenen Gesellschaftsanteile anhand der frei verfügbaren Reserven
zurückkaufen und sie wiederverkaufen. Diese Gesellschaftsanteile verleihen, solange sie sich im Gesellschaftsvermögen
befinden, weder ein Stimmrecht, noch einen Dividendenanspruch, noch einen Anspruch auf einen Teil des Abwicklung-
serlöses, und werden auch nicht bei der Erstellung eines Quorums berücksichtigt. Im Falle eines Wiederverkaufs, wird
die Gesellschaft gemäß den Bestimmungen von Artikel zehn vorgehen.

Art. 12. Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Geschäftsführer(n), die keine Gesellschafter

sein müssen. Sie werden von der Hauptversammlung der Gesellschafter ernannt und abberufen, welche deren Befugnisse
und die Dauer ihrer Funktionen festlegt und mit einfacher Mehrheit der das Gesellschaftskapital vertretenden Anteile
erkennt. Sie sind wieder wählbar und können jederzeit ohne Kündigungsfrist abberufen werden.

Die Geschäftsführer sind befugt, jedoch nur gemeinsam und einstimmig, einen Teil ihrer Befugnisse an Bevollmächtigte

und/oder an Direktoren zu übertragen.

181026

L

U X E M B O U R G

Art. 13. Der oder die Geschäftsführer gehen aufgrund ihrer Funktion keinerlei persönliche Verpflichtung in Bezug auf

die regelmäßig von ihnen namens der Gesellschaft eingegangenen Verpflichtungen ein; in ihrer Eigenschaft als reine Be-
vollmächtigten, haften sie lediglich für die ordnungsgemäße Erfüllung ihres Mandats.

Art. 14. Jeder Gesellschafter kann unabhängig von der Zahl der von ihm gehaltenen Gesellschaftsanteile an der ge-

meinsamen Beschlussfassung teilnehmen.

Jeder Gesellschafter kann so viele Stimmen abgeben, wie er Gesellschaftsanteile besitzt.
Jeder Gesellschafter kann sich an den Versammlungen rechtsgültig durch einen Spezialbevollmächtigten vertreten las-

sen.

Art. 15. Gemeinsame Beschlüsse gelten nur dann als ordnungsgemäß gefasst, wenn sie von Gesellschaftern verab-

schiedet werden, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten.

Die Beschlüsse betreffend eine Satzungsänderung können ebenfalls mit einfacher Mehrheit der das Gesellschaftskapital

vertretenden Anteile gefasst werden. Die entsprechenden Bestimmungen der Artikel 194 und 199 des Gesetzes über die
Handelsgesellschaften finden demnach keine Anwendung.

Art. 16. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.

Art. 17. Jedes Jahr werden am einunddreißigsten Dezember die Abschlüsse der Gesellschaft erstellt, und die Ge-

schäftsführung verfasst ein Inventar mit der Wertangabe der Aktiva und Passiva der Gesellschaft, sowie eine Bilanz und
eine Gewinn- und Verlustrechnung.

Art. 18. Der in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresüberschuss, nach Abzug der allgemeinen Kosten, Abschrei-

bungen und Rückstellungen, stellt den Nettogewinn des Geschäftsjahres dar.

Von diesem Nettogewinn werden fünf Prozent der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent des Ge-

sellschaftskapitals erreicht hat.

Der Saldo steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.

Art. 19.  Im  Falle  einer  vorzeitigen  Auflösung  der  Gesellschaft  erfolgt  die  Abwicklung  durch  die  fungierenden  Ge-

schäftsführer,  vorbehaltlich  eines  anderweitigen  Beschlusses  der  Hauptversammlung  der  Gesellschafter.  Das  aktive
Ergebnis der Abwicklung, nach Bereinigung aller Passiva, wird unter die Inhaber der Gesellschaftsanteile anteilmäßig zur
Zahl der in ihrem Besitz befindlichen Anteile verteilt.

Art. 20. Für alle in der vorliegenden Satzung nicht vorgesehenen Punkte verweisen die Gesellschafter auf die gesetz-

lichen Bestimmungen.

<i>Übergangsbestimmung

Ausnahmsweise beginnt das erste Geschäftsjahr am Gründungsdatum der Gesellschaft und endet am einunddreißigsten

Dezember zweitausendvierzehn.

<i>Zeichnung und Einzahlung

Die Geschäftsanteile werden gezeichnet wie folgt:

1.- Frau Sarina SOLEIMANI, vorbenannt, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anteile 125
TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anteile 125

All diese Anteile wurden voll und in bar eingezahlt, so dass der Betrag von ZWÖLFTAUSENDFÜNFHUNDERT EURO

(EUR 12.500.-) der Gesellschaft von heute an zur Verfügung steht, wie dies der unterzeichneten Notarin ausdrücklich
nachgewiesen wurde.

<i>Feststellung

Die beurkundende Notarin bestätigt, dass die in Artikel 183 des Gesetzes vom 10. August 1915, in seiner abgeänderten

Fassung, vorgesehenen Bedingungen erfüllt wurden.

<i>Kosten

Die Kosten, Lasten, Auslagen, oder Vergütungen jedweder Art, die der Gesellschaft im Zusammenhang mit ihrer

Gründung entstehen oder auferlegt werden, werden unter jedem Vorbehalt auf etwa 1.200 Euro veranschlagt.

<i>Außerordentliche Hauptversammlung

Anschließend ist die Gesellschafterin, welche das gesamte Gesellschaftskapital vertritt und sich als ordnungsgemäß

einberufen betrachtet, zu einer außerordentlichen Hauptversammlung zusammengetreten ist und haben einstimmig die
folgenden Beschlüsse bestimmt hat:

- Der Sitz der Gesellschaft wird in L-6665 Herborn, 19, Haaptstrooss, festgelegt.
Folgende Person wird auf unbestimmte Zeit zum Geschäftsführer der Gesellschaft ernannt:
Frau Sarina SOLEIMANI, geboren zu Téhéran (Iran) am 18. September 1983, wohnhaft in L-6695 Herborn, 19, Haapts-

trooss, als alleiniger Geschäftsführer.

181027

L

U X E M B O U R G

Die Gesellschaft wird unter allen Umständen durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers verpflichtet.
Die unterzeichnete Notarin welche der deutschen Sprache passiv und aktiv mächtig ist, stellt hiermit fest, dass auf

Ersuchen der obengenannten vorsprechenden Parteien die vorliegende notarielle Urkunde in deutscher Sprache abgefasst
ist, wobei eine französiche Übersetzung nachfolgt; auf Ersuchen der oben genannten vorsprechenden Parteien hat im Fall
von Abweichungen zwischen dem deutschen und dem französichen Text die deutsche Fassung Vorrang.

WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Esch-sur-Alzette, in der Kanzlei der beurkundenden Notarin, Datum wie

eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Auslegung an die Komparenten, die der Notarin mit Namen, üblichen Vornamen, Zivilstand

und Wohnort bekannt sind, haben sie die vorliegende Urkunde zusammen mit der Notarin unterzeichnet.

Suit la traduction en langue française:

L'an deux mille quatorze, le dix-huit novembre
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette,

A comparu:

Madame Sarina SOLEIMANI, née le 18 septembre 1983 à Téhéran (Iran), demeurant à L-6665 Herborn, 19, Haapts-

trooss,

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à res-

ponsabilité limitée qu'elle déclare constituer:

Art. 1 

er

 .  Entre la partie ci-avant désignée et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des parts

sociales ci-après créées, il est formé une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, régie par les présents
statuts et par la législation luxembourgeoise afférente.

Art. 2. La société prend la dénomination de:
«ExIP S.à r.l.».

Art. 3. Le siège social est établi à Herborn.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision du ou des

gérants qui auront tous les pouvoirs d'adapter le présent article.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Tout associé pourra dénoncer sa participation dans la société. La dénonciation se fera par lettre recommandée envoyée

aux associés et aux gérants avec un préavis de six mois avant l’échéance. L'associé désireux de sortir de la société suivra
les dispositions de l’article dix des statuts.

Sans préjudice de ce qui précède, la société pourra être dissoute avant terme par une décision prise à la majorité

simple du capital social.

Art. 5. La société peut acquérir et mettre en valeur tous brevets, licences, marques commerciales et autres droits se

rattachant à ces brevets, licences et marques commerciales ou pouvant les compléter ainsi que leur exploitation.

En outre, la société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute
autre manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets
et autres valeurs de toutes espèces, l’administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale, tant au Luxembourg qu'à l’étranger et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de
toute autre manière.

La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts et procéder à l’émission d'obligations,

à différentes sociétés (filiales ou non).

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou

indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public.

La société a pour objet l’achat, la vente, la mise en location, l’administration et la mise en valeur sous quelque forme

que ce soit de biens immobiliers situés au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger, ainsi que toutes opérations
commerciales ou financières, immobilières ou mobilières qui s'y rattachent directement ou indirectement.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu'elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.

La société a encore pour objet de percevoir des indemnités et des rémunérations des sociétés du groupe ainsi que

l’administration et la gérance de telles sociétés du groupe, à qui elle pourra notamment fournir toute prestation d’assis-
tance stratégique, administrative ou commerciale.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents Euros (12.500.-€), représenté par cent vingt-cinq

(125) parts sociales de cent Euros (100.-€) chacune.

181028

L

U X E M B O U R G

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.

Art. 8. Les copropriétaires indivis de parts sociales, les nus-propriétaires et les usufruitiers sont tenus de se faire

représenter auprès de la société par une seule et même personne agréée préalablement par décision des associés, prise
à la majorité simple du capital. L'agrément ne pourra être refusé que pour de justes motifs.

Art. 9. Les parts sociales sont librement transmissibles pour cause de mort, même par disposition de dernière volonté,

à condition que ce soit en ligne directe ou au conjoint survivant. Tout autre bénéficiaire devra être agréé par une décision
prise à l’unanimité des associés survivants. En cas de refus, le bénéficiaire devra procéder conformément à l’article dix
des statuts, à l’exclusion du dernier alinéa, et sera lié par le résultat de l’expertise. Au cas où aucun associé n'est disposé
à acquérir les parts au prix fixé, le bénéficiaire sera associé de plein droit.

Art. 10.
a) Si un associé se propose de céder tout ou partie de ses parts sociales, de même qu'aux cas pré-visés aux articles

quatre et neuf, il doit les offrir à ses co-associés proportionnellement à leur participation dans la société.

b) En cas de désaccord persistant des associés sur le prix après un délai de deux semaines, le ou les associés qui

entendent céder les parts, le ou les associés qui se proposent de les acquérir, chargeront de part et d'autre un expert
pour fixer la valeur de cession, en se basant sur la valeur vénale des parts.

c) La société communique par lettre recommandée le résultat de l’expertise à tous les associés, en les invitant à faire

savoir dans un délai de quatre semaines s'ils sont disposés à acheter ou à céder les parts au prix arrêté. Si plusieurs
associés déclarent vouloir acquérir les parts proposées à la vente, elles seront offertes aux associés qui entendent les
acquérir en proportion de leur participation dans la société. Le silence des associés pendant le prédit délai de quatre
semaines équivaut à un refus.

d) Dans ce cas, l’associé qui entend les céder peut les offrir à des non-associés, étant entendu qu'un droit de préemption

est encore réservé aux autres associés en proportion de leurs participations pendant un délai de deux semaines à partir
de la date de la communication de l’accord avec des tiers et suivant les conditions de celui-ci. L'article 189 de la loi sur
les sociétés commerciales est remplacé par les articles neuf et dix des présents statuts.

Art. 11. La société peut, sur décision de l’assemblée générale, prise à la majorité du capital social, procéder au rachat

de ses propres parts sociales au moyen de réserves libres ainsi qu'à leur revente. Ces parts sociales, aussi longtemps
qu'elles se trouvent dans le patrimoine de la société, ne donnent droit ni à un droit de vote, ni à des dividendes, ni à une
part du produit de la liquidation et elles ne sont pas prises en considération pour l’établissement d'un quorum. En cas de
revente, la société procédera suivant les dispositions de l’article dix.

Art. 12.  La  société  est  administrée  par  un  ou  plusieurs  gérants,  associés  ou  non.  Ils  sont  nommés,  révoqués  par

l’assemblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions, et qui statue à la majorité
simple du capital. Ils sont rééligibles et révocables ad nutum et à tout moment.

Les gérants ont le droit, mais seulement collectivement et à l’unanimité, de déléguer partie de leurs pouvoirs à des

fondés de pouvoirs et ou à des directeurs.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quelque soit le nombre de parts qui lui appartiennent.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède.
Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles aient été adoptées par des associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions ayant pour objet une modification des statuts pourront également être prises à la majorité simple du

capital social. Les dispositions y afférentes des articles 194 et 199 de la loi sur les sociétés commerciales ne trouveront
donc pas application.

Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

Art. 17. Chaque année, le trente-et-un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société ainsi qu'un bilan et un compte de profits et pertes.

Art. 18. L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, amortissements et provisions,

résultant des comptes annuels, constitue le bénéfice net de l’exercice.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légal, jusqu'à ce que celui-

ci atteint le dixième du capital social.

Le solde est à la libre disposition des associés.

181029

L

U X E M B O U R G

Art. 19. En cas de dissolution anticipée de la société, la liquidation sera faite par les gérants en exercice, à moins que

l’assemblée générale des associés n'en décide autrement. Le résultat, actif de la liquidation, après apurement de l’intégralité
du passif, sera réparti entre les propriétaires des parts sociales, au prorata du nombre de leurs parts.

Art. 20. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement, le premier exercice commence le jour de la constitution et finira le trente-et-un décembre de

l’an deux mille quatorze.

<i>Souscription et Libération

La comparante précitée présente a souscrit aux parts créées de la manière suivante:

1.- Mme. Sarina SOLEIMANI, pré-qualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 parts
TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 parts

Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de DOUZE MILLE

CINQ CENTS EUROS (€ 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié
au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues à l’article 183 de la loi du 10 août 1915, telle que

modifiée par la suite, ont été remplies.

<i>Frais

Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à la somme approximative de 1.200
euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant l’associée, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoquée, s'est

réunie en assemblée générale extraordinaire et à pris les résolutions suivantes:

- L'adresse de la société est fixée à L-6665 Herborn, 19, Haaptstrooss.
Est nommée gérant unique de la société pour une durée indéterminée:
Madame Sarina SOLEIMANI, née le 18 septembre 1983 à Téhéran (Iran), demeurant à L-6665 Herborn, 19, Haapts-

trooss,

La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature du gérant unique.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’allemand déclare qu’à la requête de la partie comparante, le présent acte

a été établi en allemand, suivi d’une version Française. A la requête de la même partie comparante, et en cas de divergence
entre le texte allemand et le texte français, la version allemande fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par noms, prénoms usuels, état et

demeure, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: SOLEIMANI, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 19/11/2014. Relation: EAC/2014/15634. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): HALSDORF.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 21 novembre 2014.

Référence de publication: 2014184142/295.
(140207757) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2014.

Filotel S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 180.991.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014183410/9.
(140206252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2014.

181030

L

U X E M B O U R G

Lucenda S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Halian S.à r.l.).

Capital social: EUR 370.000,00.

Siège social: L-1274 Howald, 23, rue des Bruyères.

R.C.S. Luxembourg B 136.576.

In the year two thousand fourteen, on the fifth day of November.
Before Us, Maître Cosita DELVAUX, notary residing in Luxembourg,

Was held

an extraordinary general meeting of the shareholders of HALIAN PSF S.à r.l., a “private limited liability company”,

having  its  registered  office  at  L-1274  HOWALD,  23,  rue  des  Bruyères,  registered  with  the  Luxembourg  Trade  and
Companies Register in Luxembourg under number B 136576, incorporated on January 30, 2008, pursuant to a notarial
deed of Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et As-
sociations (the “Mémorial C”), number 729 on March 26, 2008. The articles of association of the Company have been
amended for the last time by deed of the notary Gérard LECUIT, residing in Luxembourg, on October 1, 2010, published
in the Mémorial C number 2620 on December 1, 2010.

The meeting was presided over by Maître Cintia Martins Costa, maître en droit, professionally residing in Luxembourg.
Maître Mariya GADZHALOVA, Maître en droit, professionally residing in Luxembourg, was appointed as secretary

and scrutineer.

The board of the Meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the undersigned notary

to enact the following:

I. The present extraordinary general meeting of shareholders of the Company has been convened by a convening

notice sent by registered mail on 27 

th

 October 2014 to all the shareholders inscribed in the shareholders’ register of

the Company at least eight (8) days prior to the present meeting, in accordance with the articles of association of the
Company.

II. The capital of the Company is set at three hundred and seventy thousand euros (370.000,- EUR) represented by

one hundred (100) shares with a par value of three thousand and seven hundred euros (3.700,- EUR) each, all subscribed
and fully paid-up. An attendance list of the shareholders of the Company present or represented was drawn up on the
basis of an electronic extract from the RCS relating to the Company dated 4 

th

 November 2014 and the original share-

holders’ register of the Company which were both tabled at the meeting. The said list together with the proxies, after
having been signed "ne varietur" by the proxyholders, chairman, secretary, srutineer and the undersigned notary, will
remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

III. As it appears from the said list, one hundred (100) shares, representing 100 % capital of the Company, were

represented at the meeting so that the meeting was regularly constituted and could validly decide on all the items of the
agenda.

IV. The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1. Acknowledgement and confirmation of the transfer by Antpenny AG of one (1) share of the Company to Mr Levon

Antonian with effect as from 13 October 2014;

2. Change of the name of the Company to “Lucenda S.à r.l.” and subsequent amendment of article 1 of the articles of

association of the Company;

3. Change of the corporate object of the Company to remove any reference to activities requiring a licence under the

law of 5 April 1993 on the financial sector, as amended (the “Law of 1993”), and subsequent restatement of article 3 of
the articles of association of the Company so as to read as follows:

“ Art. 3. Object. The object of the Company is the commercialisation, distribution, buying and selling of computer

programs and accessories as well as the provision of services as an IT systems operator.

The company may acquire, exploit and sell all know-how trademarks and licenses.
The Company may, alone or in participation with other companies, for its own account or for the account of others,

carry out all types of operations which relate directly or indirectly to the other activities.

The Company may take participations in whatever form in other companies which have identical or similar object to

its own.

In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable,

commercial and industrial operation which it may deem useful for the accomplishment and development of its purpose.”

4. Decision to put the Company into liquidation and to dissolve it;

181031

L

U X E M B O U R G

5. Subject to the approval of item 4. above, appointment of Aumea Partner S.àr.l., cabinet de revision agréé, represented

by Mrs Michèle Perez, réviseur d’entreprise agréé, with registered office at 26-28 rue Edward Steichen L-2540 Luxem-
bourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register in Luxembourg under number B180716, as
liquidator of the Company, determination of the powers of the liquidator and granting the largest powers and especially
those determined by articles 144 and 145 and following of the Law of 10 

th

 August 1915 on commercial companies (as

amended) to the liquidator by the general meeting of shareholders of the Company.”

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting took the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting of the shareholders acknowledged and, to the extent required, decided to confirm the transfer

by Antpenny AG of one (1) share of the Company to Mr Levon Antonian with effect as from 13 October 2014 on the
basis of the written shareholders’ resolution of the Company dated 13 October 2014 a copy of which was tabled at the
meeting.

For: 79

Against: 20

Abstentions: 1

Pursuant to the above a total of 79 % of the votes cast at the present meeting have voted in favour, so that the resolution

has been adopted.

<i>Second resolution

The general meeting of the shareholders decided to change the name of the Company into “Lucenda S.à r.l.” and in

consequence, to amend and restate article 1 of the articles of association of the Company so as to read as follows:

Art. 1. Name. There is formed a private limited liability company (“société à responsabilité limitée”) under the name

Lucenda S.à r.l., (hereinafter the “Company”), which will be governed by the laws in effect and especially by those of
August 10, 1915 concerning commercial companies as amended, and September 18, 1933 on private limited liability
companies, as amended (hereinafter the “Law”), as well as by the present articles of association (hereinafter the “Arti-
cles”)."

For: 80

Against: 0

Abstentions: 20

Pursuant to the above a total of 80 % of the votes cast at the present meeting have voted in favour, so that the resolution

has been adopted.

<i>Third resolution

The general meeting of the shareholders resolved to amend the corporate object of the Company in order to remove

any reference to activities requiring a licence under the Law of 1993, and, to subsequently amend and restate article 3 of
the articles of association of the Company so as to read as follows:

“ Art. 3. Object. The object of the Company is the commercialisation, distribution, buying and selling of computer

programs and accessories as well as the provision of services as an IT systems operator.

The Company may acquire, exploit and sell all know-how trademarks and licenses.
The Company may, alone or in participation with other companies, for its own account or for the account of others,

carry out all types of operations which relate directly or indirectly to the other activities.

The Company may take participations in whatever form in other companies which have identical or similar object to

its own.

In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable,

commercial and industrial operation which it may deem useful for the accomplishment and development of its purpose.”

For: 80

Against: 20

Abstentions: 0

Pursuant to the above a total of 80 % of the votes cast at the present meeting have voted in favour, so that the resolution

has been adopted.

<i>Fourth resolution

The general meeting of the shareholders resolved to put the Company into liquidation and to dissolve it (the Company

subsisting for the sole purpose of the liquidation).

For: 80

Against: 20

Abstentions: 0

Pursuant to the above a total of 80 % of the votes cast at the present meeting have voted in favour, so that the resolution

has been adopted.

<i>Fifth resolution

The general meeting of the shareholders resolved to appoint as liquidator Aumea Partner S.àr.l., cabinet de révision

agréé, represented by Mrs Michèle Perez, réviseur d’entreprise agréé (as defined in item 4 of the agenda above) a and to
grant it the largest powers and particularly those set forth in articles 144 and following of the Law of 10 

th

 August 1915

on commercial companies (as amended).

181032

L

U X E M B O U R G

The general meeting of the shareholders resolved to authorise the liquidator in advance to execute the acts and enter

into the operations set forth in article 145 of the same law without any special authorisation, if such authorisation is
required by law.

The liquidator is discharged by the general meeting of the shareholders to make an inventory and can simply refer to

the documents of the Company.

The liquidator, under its responsibility, for specific operations or contracts, delegate to one or more proxies part of

its powers to determine.

The liquidator is authorised, with respect to the limits permitted by law, to proceed to the payment of any interim

liquidation proceeds that would consider appropriate.

For: 80

Against: 20

Abstentions: 0

Pursuant to the above a total of 80 % of the votes cast at the present meeting have voted in favour, so that the resolution

has been adopted.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

<i>Costs

The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at approximately EUR 1,500.-.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing persons, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the members of the bureau, the members of the bureau signed together with the

notary the present original deed.

Follows the french version suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le cinquième jour du mois de novembre.
Par-devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est tenue

une assemblée générale extraordinaire des associés de HALIAN PSF S.à.r.l., une société à responsabilité limitée, ayant

son siège sociale au L-1274 Howald, 23, rue des Bruyères, immatriculée au Registre de Commerce et des Société de
Luxembourg sous le numéro B 136576, constituée en date du 30 janvier 2008 suivant acte notarié de Maître Paul Frieders,
notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial C»),
numéro 729 du 26 mars 2008. Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire
Gérard LECUIT à Luxembourg en date du 1 

er

 octobre 2010, publié au Mémorial C, numéro 2620 du 1 

er

 décembre

2010.

L’assemblée s’est tenue sous la présidence de Maître Cintia Martins Costa, maître en droit, demeurant profession-

nellement à Luxembourg.

Maître Mariya GADZHALOVA, Maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg, a été nommé en tant

que secrétaire et scrutateur.

Une fois le bureau de l’assemblée constitué, le président a déclaré et requis le notaire d’acter ce qui suit:
I. La présente assemblée générale extraordinaire des associés de la Société a été convoquée par courrier recommandé

avec accusé de réception envoyée le 27 octobre 2014 à tous les associés inscrits dans le registre des associés de la Société
au moins huit (8) jours avant la présente assemblée, conformément aux statuts de la Société.

II. Le capital social de la Société est fixé à trois cent soixante-dix mille euros (370,000.- EUR) représenté par cent (100)

parts sociales d’une valeur nominale de trois mille sept cents euros (3.700,- EUR) chacune, toutes souscrites et entière-
ment libérées. Une liste de présence des associés présents ou représentés a été établie sur base d’un extrait électronique
du RCS relatif à la Société et le registre des associés de la Société lesquels ont été tous deux présentés à l’assemblée.
Ladite liste restera annexée au présent acte ensemble avec les procurations, après avoir été signée «ne varietur» par les
mandataires, le président, le secrétaire et scrutateur et le notaire instrumentant, pour les formalités d’enregistrement.

III. Il apparaît de ladite liste que cent (100) parts sociales représentant 100 % du capital social sont représentées à la

présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée est valablement constituée et peut valablement
prendre des résolutions sur tous les points portés à l’ordre du jour.

IV. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. Constat et confirmation du transfert par Antpenny AG d’une (1) part sociale de la Société à M. Levon Antonian

avec effet au 13 octobre 2014;

181033

L

U X E M B O U R G

2. Changement de dénomination de la Société en “Lucenda S.à r.l.” et modification conséquente de l’article 1 des

statuts de la Société;

3. Modification de l’objet social de la Société afin de supprimer toute référence à des activités qui requièrent un

agrément en vertu de la loi au 5 avril 1993 sur le secteur financier, telle que modifiée (la «Loi de 1993»), et modification
conséquente de l’article 3 des statuts de la Société de manière à lire ce qui suit:

“ Art. 3. Objet social. La société a pour objet la commercialisation, la distribution, l’achat et la vente de tous pro-

grammes  informatiques  et  accessoires  ainsi  que  la  prestation  de  tous  services  en  tant  qu'opérateurs  de  systèmes
informatiques

La société peut acquérir, exploiter et vendre des marques brevetées en savoir-faire et licences.
La société peut, soit pour son propre compte, soit en participation avec d'autres sociétés pour son propre compte

ou pour le compte d'autres, exécuter tous types d'opérations en relation directe ou indirecte aux autres activités.

La société peut prendre des participations sous quelque forme que ce soit dans d'autres sociétés ayant une raison

sociale identique ou similaire.

D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toute opération finan-

cière, mobilière ou immobilière, commerciale ou industrielle qu'elle jugera utile à l’accomplissement et au développement
de son objet.”

4. Décision de mettre la Société en liquidation et de la dissoudre;
5. Sous réserve de l’approbation du point 4 ci-dessus, nomination de Aumea Partner S.àr.l., cabinet de révision agréé,

avec siège social au 26-28 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B180716, en tant que liquidateur de la Société, détermination des pouvoirs du
liquidateur et octroi des pouvoirs les plus larges et notamment ceux indiqués aux articles 144 et 145 et suivants de la loi
du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (telle que modifiée) au liquidateur par l’assemblée générale des
associés de la Société.”

Ces faits exposés et reconnus par l’assemblée, cette dernière a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale des associés a constaté et, pour autant que ce soit nécessaire, a décidé de confirmer le transfert

par Antpenny AG d’une (1) part sociale de la Société à M. Levon Antonian avec effet au 13 octobre 2014 sur base de la
résolution écrite des associés datée le 13 octobre 2014 dont une copie a été présentée à l’assemblée.

Pour:79

Contre: 20

Abstentions: 1

Suivant ce qui précède un total de 79 % des votes exprimés lors de la présente assemblée ont voté en faveur, de sorte

que la résolution a été adoptée.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale des associés a décidé de changer la dénomination de la Société en “Lucenda S.à r.l.” et de modifier

en conséquence l’article 1 des statuts de la Société de manière à lire ce qui suit:

«  Art. 1 

er

 . Dénomination.  Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination Lucenda S.à r.l., (la

«Société»), qui sera régie par les lois actuellement en vigueur, notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales telle que modifiée, et par celle du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée telle que
modifiée, (ci-après la «Loi») ainsi que par les présents statuts (ci-après les «Statuts»).»

Pour: 80

Contre: 0

Abstentions: 20

Suivant ce qui précède un total de 80 % des votes exprimés lors de la présente assemblée ont voté en faveur, de sorte

que la résolution a été adoptée.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale des associés a décidé de modifier l’objet social de la Société afin de supprimer toute référence

à des activités qui requièrent un agrément en vertu de la Loi de 1993 et de modifier en conséquence l’article 3 des statuts
de la Société de manière à lire ce qui suit:

“ Art. 3. Object. La société a pour objet la commercialisation, la distribution, l’achat et la vente de tous programmes

informatiques et accessoires ainsi que la prestation de tous services en tant qu'opérateurs de systèmes informatiques

La société peut acquérir, exploiter et vendre des marques brevetées en savoir-faire et licences.
La société peut, soit pour son propre compte, soit en participation avec d'autres sociétés pour son propre compte

ou pour le compte d'autres, exécuter tous types d'opérations en relation directe ou indirecte aux autres activités.

La société peut prendre des participations sous quelque forme que ce soit dans d'autres sociétés ayant une raison

sociale identique ou similaire.

D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toute opération finan-

cière, mobilière ou immobilière, commerciale ou industrielle qu'elle jugera utile à l’accomplissement et au développement
de son objet.”

181034

L

U X E M B O U R G

Pour: 80

Contre: 20

Abstentions: 0

Suivant ce qui précède un total de 80 % des votes exprimés lors de la présente assemblée ont voté en faveur, de sorte

que la résolution a été adoptée.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale des associés a décidé de mettre la Société en liquidation et de la dissoudre (la Société ne subsistant

que pour les besoins de la liquidation).

Pour: 80

Contre: 20

Abstentions: 0

Suivant ce qui précède un total de 80 % des votes exprimés lors de la présente assemblée ont voté en faveur, de sorte

que la résolution a été adoptée.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale des associés a décidé de nommer Aumea Partner S.àr.l., cabinet de révision agréé, représenté

par Mrs Michèle Perez, réviseur d’entreprise agréé (telle qu’identifiée au point 4 de l’agenda ci-dessous) en tant que
liquidateur de la Société, et de lui donner les pouvoirs les plus larges et notamment ceux indiqués aux articles 144 et 145
et suivants de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (telle que modifiée).

L’assemblée générale des associés a décidé d’autoriser par avance le liquidateur à exécuter tous actes et opérations

tels que définis dans l’article 145 de la même loi sans autorisation spéciale, pour autant qu’une telle autorisation était
requise par la loi.

Le liquidateur est déchargé par l’assemblée générale des associés de dresser un inventaire et peut simplement renvoyer

aux documents de la Société.

Le liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations ou des contrats spécifiques, déléguer à un ou plusieurs

mandataires une partie de ses pouvoirs.

Le liquidateur est autorisé, dans le respect des limites permises par la loi, de procéder au paiement de tout boni de

liquidation intérimaire qu’il considérera comme approprié.

Pour: 80

Contre: 20

Abstentions: 0

Suivant ce qui précède un total de 80 % des votes exprimés lors de la présente assemblée ont voté en faveur, de sorte

que la résolution a été adoptée.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison des présentes est évalué à environ EUR 1.500,-.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. MARTINS COSTA, M. GADZHALOVA, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 07 novembre 2014. Relation: LAC/2014/52161. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 novembre 2014.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2014179220/257.
(140205717) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2014.

FR Prime Holdings III (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 32.000,00.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 173.239.

Les comptes annuels au 30 septembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 novembre 2014.

Référence de publication: 2014179178/10.
(140205279) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2014.

181035

L

U X E M B O U R G

Kant Capital Fund S.C.A. SICAV-SIF, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investisse-

ment Spécialisé.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue John F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 191.784.

STATUTES

In the year two thousand fourteen, on the twenty-first day of October.
Before us, Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-Sur Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Kant Capital S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated

pursuant to a deed of Maître Francis Kesseler on October 21, 2014, not yet published in the Mémorial C de Recueil des
Sociétés et Associations, in process of registration with the Luxembourg Register of Commerce and Companies, having
a share capital of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500) (the “General Partner”); and

Mr Girolamo Stabile, entrepreneur, born in Mazara del Vallo, Italy on September 15, 1973, with professional address

at Via A. Bertoloni, 26B, 00197 Roma, Italy,

here represented by Maître Luc Courtois, attorney at law, with professional address at 2 rue Peternelchen, Immeuble

C2, L-2370 Howald, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of two powers of attorney given on October 8, 2014.

Such powers of attorney, after having been signed ne varietur by the representatives of the appearing parties and the

undersigned notary, will remain annexed to this deed for the purpose of registration.

The appearing parties, represented as above, have requested the undersigned notary to state as follows the articles

of incorporation of a partnership limited by shares (société en commandite par actions), which is hereby incorporated:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Formation and Name.
1.1. There exists among the General Partner and the persons who become owners of the shares issued in accordance

with the following and all those who may become Shareholders in the future an investment company with variable capital
- specialised investment fund (société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé - SICAV-SIF)
in the form of a partnership limited by shares (société en commandite par actions) (the “Company”) governed by the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg and, in particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as
amended (the “1915 Law”), the SIF Law and these articles of association (the “Articles”).

1.2. The name of the Company shall be Kant Capital Fund S.C.A. SICAV-SIF.

Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company shall be established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may

be transferred within the municipality of the City of Luxemburg by a decision of the General Partner.

2.2. The registered office may not be transferred to any place outside the Grand Duchy of Luxembourg except as

otherwise provided herein.

2.3. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a

decision of the General Partner.

Art. 3. Corporate object.
3.1. The object of the Company is to place the funds available to it in various securities and financial derivative ins-

truments utilising a broad range of conventional and alternative investment and trading strategies, within the widest
meaning permitted by the SIF Law, with the purpose of diversifying investment risk and affording its shareholders the
benefit of the management of the Company's Sub Funds.

3.2. Subject to Art. 3.7, the Company may in particular acquire by subscription, purchase and exchange or in any other

manner any stock, shares and other participation securities, hybrid securities, bonds, debentures, certificates of deposit
and other debt instruments and more generally, any securities and financial instruments issued by any public or private
entity. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise.

3.3. The Company may further issue securities, including debt instruments, as further decided by the General Partner

in accordance with the conditions and within the limits of the SIF Law and these Articles.

3.4. The Company may incur any debt from shareholders or third parties as may be decided from time to time by the

board of managers of the General Partner for purposes of financing the Company's investments in accordance with the
investment policies and restrictions applicable to the Company.

3.5. The Company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial

enterprises and may lend funds including, without limitation, the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated
companies and any other companies. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise

181036

L

U X E M B O U R G

create and grant security over all or some of its assets to guarantee its own obligations and those of any other company,
and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the avoidance of doubt, the Company
may not carry out any regulated activities of the financial sector without having obtained the required authorisation.)

3.6. Subject to Art. 3.7, the Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments

and to protect itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.7. The Company may carry out any measures and carry out any operation or transaction, which it may deem useful

in the development and accomplishment of its purpose to the full extent permitted by the SIF Law but subject, at all times,
to the limitations and investment restrictions set out in the Offering Memorandum.

Art. 4. Duration.
4.1. The Company is established for an unlimited duration. The General Partner may, however, establish Compart-

ments for a limited duration. The Company may be dissolved by a resolution of the Shareholders adopted in the manner
required for amendment of these Articles.

4.2. Subject to Art. 33.2 the Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity,

insolvency, bankruptcy or any similar event affecting one or several Shareholders.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.
5.1. The share capital of the Company (the “Share Capital”) shall be represented by fully paid-up shares of no par value

and shall at any time be equal to the total net assets of the Company as described in Art. 29 below.

5.2. The Share Capital shall be represented by the following two types of Shares:
(i) “Management Shares”: Shares which shall be subscribed by the General Partner, as unlimited shareholder (action-

naire-gérant commandité); and

(ii) “Ordinary Shares”: Shares which shall be subscribed by the limited shareholders (actionnaires commanditaires).
Ordinary Shares may only be subscribed by persons who are ‘well-informed investors' within the meaning given in the

SIF Law.

5.3. The initial share capital of the Company amounts to thirty one thousand euros (EUR 31,000) divided into
(i) One (1) Management Share which shall be subscribed by the General Partner, as unlimited shareholder (actionnaire-

gérant commandité) issued in the Company, with a subscription price of one thousand euros (EUR 1,000); and

(ii) Thirty (30) Ordinary Shares, with a subscription price of one thousand euros (EUR 1,000) per Ordinary Share,

issued as follows:

- Ten (10) Ordinary Shares in the Compartment “Kant Capital Fund S.C.A. SICAV-SIF: Unit 1”;
- Ten (10) Ordinary Shares in the Compartment “Kant Capital Fund S.C.A. SICAV-SIF: Unit 2”;
- Ten (10) Ordinary Shares in the Compartment “Kant Capital Fund S.C.A. SICAV-SIF: Unit 3”.
5.4. The minimum capital of the Company shall be one million two hundred fifty thousand euros (EUR 1,250,000),

which must be reached within twelve (12) months after the date on which the Company has been authorised in accordance
with the SIF Law.

5.5.  The  General  Partner  may,  within  each  Compartment,  at  any  time,  issue  different  classes  of  Ordinary  Shares

(collectively the “Classes” and individually a “Class”), which may carry different rights and obligations with regard to
eligible investors, income and profit entitlements, redemption features, fee and cost features and/or such other features
as may be determined by the General Partner from time to time, as fully described in the Offering Memorandum. The
General Partner may, furthermore, issue different sub-classes in any Class of Shares (collectively the “Sub-Classes” and
individually a “Sub-Class”) which may differ with regard to currency of denomination or eligible investors and/or such
other features as may be determined by the General Partner of the Company from time to time.

5.6. For the process of the consolidation of the accounts the base currency of the Company shall be euro (EUR). Each

Compartment may have its own reference currency which may differ from the base currency of the Company.

5.7. The Company may create within each Compartment an accumulation class or a distribution class, as indicated in

the Offering Memorandum. Accumulation Classes capitalise in principle their entire earnings whereas distribution Classes
pay dividends.

Art. 6. Compartments.
6.1. The Company offers a choice of Compartments as described in the Offering Memorandum, which allow investors

to make their own strategic allocation.

6.2. For each Compartment, a separate portfolio of investments and assets will be maintained. The different portfolios

will be separately invested in accordance with their specific features as described in the Offering Memorandum.

6.3. The Company is one single entity; however, the rights of investors and creditors regarding a Compartment or

raised by the constitution, operation or liquidation of a Compartment are limited to the assets of this Compartment, and
the assets of a Compartment will be answerable exclusively for the rights of the Shareholders relating to this Compartment
and for those of the creditors whose claim arose in relation to the constitution, operation or liquidation of this Com-

181037

L

U X E M B O U R G

partment. In relations between the Company's Shareholders, each Compartment is treated as a separate entity. The
assets, charges and expenses that cannot be allocated to one specific Compartment will be charged to the different
Compartments pro rata to their respective net assets, if appropriate due to the amounts considered.

6.4. The General Partner of the Company may decide at any time to create new Compartments.

Art. 7. Subscription.
7.1. Ordinary Shareholders wishing to subscribe and accept Ordinary Shares in a particular Compartment in accor-

dance with these Articles as well as the terms and conditions set forth in the Offering Memorandum shall execute a
subscription agreement (the “Subscription Agreement”), which may be accepted by the General Partner pursuant to the
terms of the Offering Memorandum and will, upon acceptance, be countersigned by the General Partner. The General
Partner may, in its sole discretion but subject at all times to the terms of the Offering Memorandum, admit additional
Ordinary Shareholders in respect of a particular Compartment and permit existing Ordinary Shareholders to increase
their subscriptions by executing an amended or an additional Subscription Agreement.

7.2. The subscription of an Ordinary Shareholder shall become effective in relation to the Company upon acceptance

of the Subscription Agreement by the General Partner and the admission to the Company shall become effective upon
the issuance of Ordinary Shares of the Company to the Shareholder.

7.3. The General Partner may delegate to any director, manager, officer, or other duly authorized agent the power to

accept subscriptions, to receive payment of the price of the Ordinary Shares to be issued and to deliver them.

Art. 8. Shares.
8.1. The Shares are indivisible and the Company recognises only one owner per Share. Joint holders of a Share shall

appoint a joint representative who shall represent them towards the Company provided that the General Partner has
the right to suspend the exercise of all rights attached to such Share until a joint representative has been appointed.
Fractions of Ordinary Shares may be issued up to four (4) decimal places and shall carry rights in proportion to the fraction
of a Ordinary Share they represent but shall carry no voting rights.

8.2. Shares will be issued in registered form and dematerialised form (“titres dématérialisés”) only and shall be fully

paid-up.

8.3. The inscription of the respective Shareholder's name in the register of registered Shares (the “Register”) evidences

its  right  of  ownership  of  such  registered  Shares.  The  Register  shall  be  kept  by  the  General  Partner  or  by  an  entity
designated therefore by the Company (the “Registrar and Transfer Agent”) and shall contain the name of each Share-
holder, its residence, registered office or elected domicile, the number of Shares (and their Class) held by it, the amount
paid in for each Share, banking references, and, if applicable, their date of transfer.

8.4. Each Shareholder may change the data contained in the Register by notice to the General Partner.
8.5. Share certificates in registered form may be issued at the discretion of the General Partner and shall be signed by

the General Partner. The costs relating to the issue of such certificates shall be borne by the Shareholder having requested
such certificate.

8.6. In the case of dematerialised Shares, the inscription of the Shareholder's name in an issue account (“compte

d'émission”) held with one single securities settlement system (within the meaning of the Luxembourg law of 10 November
2009  on  payment  services)  (“organisme  de  liquidation”)  or  one  single  central  account  holder  (licensed  by  the  CSSF
(“teneur de compte central”) appointed by the General Partner, evidences its right of ownership.

8.7. Dematerialised Shares will be evidenced by a book entry. Transfer of dematerialised shares is effected by book

entry transfer between accounts.

8.8. The Luxembourg or foreign intermediaries (“teneurs de compte”) will issue certificates, relating to the demate-

rialised Shares for the exercise of the Shareholders' rights against the issuer and third parties, such certificates will state
if they hold the securities for their own account or act as proxy for another person.

Art. 9. Issuance of Shares.
9.1. Ordinary Shares will be issued by the General Partner or its appointed agent on behalf of the Company, provided

however that payment for those Shares has been received by the General Partner or the Registrar and Transfer Agent.

9.2. Ordinary Shares may only be subscribed by Well-Informed Investors.
9.3. Subject to the terms of the Offering Memorandum and this Art. 9, the General Partner is authorised to issue an

unlimited number of Ordinary Shares at an offer price to be determined by the General Partner in accordance with the
Offering Memorandum, in its sole and absolute discretion without reserving to the existing Shareholders a preferential
right to subscribe for such Ordinary Shares to be issued.

9.4. The General Partner may impose restrictions on the frequency at which Ordinary Shares shall be issued in any

Class and/or in any Compartment; the General Partner may, in particular, decide that Ordinary Shares of any Class and/
or of any Compartment shall only be issued during one or more offering periods or at such other periodicity as provided
for in the Offering Memorandum.

9.5. In addition to the restriction in 9.2, the General Partner may determine any other subscription conditions such

as the minimum amount of subscriptions, the minimum initial subscription amount, the minimum additional subscription

181038

L

U X E M B O U R G

amount, restrictions on the ownership of shares, the minimum amount of any holding of shares and any other terms and
conditions governing the offering of new shares. The General Partner shall also be free to levy a subscription or late
entrance charge and waive any rights to such subscription or late entrance charge. Such other conditions shall be disclosed
and more fully described in the Offering Memorandum.

9.6. Each newly issued Ordinary Share shall entitle its holder to the same rights and obligations as the holders of existing

Ordinary Shares.

9.7. The Company may, if a prospective shareholder requests and the General Partner so agrees, satisfy any application

for subscription of Ordinary Shares which is proposed to be made by way of contribution in kind. The nature and type
of  assets  to  be  accepted  in  any  such  case  shall  be  determined  by  the  General  Partner  and  must  correspond  to  the
investment policy and restrictions of the Company or the Compartment being invested in. A valuation report relating to
the contributed assets must be delivered to the General Partner by a Luxembourg independent auditor.

Art. 10. Redemption of Shares.
10.1. The General Partner shall determine whether Shareholders of any particular Compartment may request the

redemption of all or part of their Ordinary Shares by the Company or not, and reflect the terms and procedures applicable
in the Offering Memorandum and within the limits provided by law and these Articles.

10.2. The Company shall not proceed to redeem Ordinary Shares in the event the net assets of the Company would

fall below the minimum capital foreseen in the SIF Law as a result of such redemption.

10.3. The redemption price shall be determined in accordance with the rules and guidelines fixed by the General

Partner and reflected in the Offering Memorandum. The price so determined shall be payable within a period as deter-
mined by the General Partner and reflected in the Offering Memorandum.

10.4. If as a result of any request for redemption, the number or the aggregate net asset value of the shares held by

any shareholder in any Class would fall below such number or such value as determined by the General Partner, then the
Company may decide that this request be treated as a request for redemption for the full balance of such shareholder's
holding of shares in such Class.

10.5. Further, if, with respect to any given Valuation Day, redemption requests pursuant to this article and conversion

requests pursuant to Art. 11 hereof exceed a certain level determined by the General Partner in relation to the number
of shares in issue in a specific Compartment or Class, the General Partner may decide that part or all of such requests
for redemption or conversion will be deferred for a period and in a manner that the General Partner considers to be in
the best interest of the Company. Following that period, with respect to the next relevant Valuation Day, these redemp-
tion and conversion requests will be met in priority to later requests.

10.6. The Company may redeem Ordinary Shares whenever the General Partner considers redemption to be in the

best interests of the Company or a Compartment. Ordinary Shares may be redeemed on a pro rata basis from all existing
Ordinary Shareholders, for example, (i) in order to distribute to the shareholders upon the disposal of an investment
asset by the Company the net proceeds of such investment, or (ii) if there has been an adverse change in the economic
or political situation.

10.7. The Ordinary Shares may also be redeemed compulsorily if the relevant shareholder ceases to be or is found

not to be a Well-Informed Investor.

10.8. The Company shall have the right, if the General Partner so determines, to satisfy in kind the payment of the

redemption price to any Ordinary Shareholder who agrees by allocating to the Ordinary Shareholder investments from
the portfolio of assets of the Company or the relevant Compartment(s) equal to the value of the Ordinary Shares to be
redeemed. The nature and type of assets to be transferred in such case shall be determined on a fair and reasonable basis
and without prejudicing the interests of the other Shareholders of the Company or the relevant Sub Fund(s) and the
valuation used shall be confirmed by a special report of a Luxembourg independent auditor. The costs of any such transfers
shall be borne by the transferee.

10.9. Any such redemption will be considered a distribution in the context of the determination of the rights of the

Shareholders pursuant to the distribution policy as more particularly described in the Offering Memorandum

10.10. The General Partner shall determine the terms and timing of any redemption in its sole and absolute discretion.

Art. 11. Conversion.
11.1. Unless otherwise determined by the General Partner for certain Classes or with respect to specific Compart-

ments in the Offering Memorandum, Shareholders are not entitled to require the conversion of whole or part of their
shares of any Class of a Compartment into shares of the same Class in another Compartment or into shares of another
existing Class of that or another Compartment. When authorized, such conversions shall be subject to such restrictions
as to the terms, conditions and payment of such charges and commissions as the General Partner shall determine.

11.2. The conversion price shall be determined in accordance with the rules and guidelines fixed by the General Partner

and reflected in the Offering Memorandum.^

Art. 12. Transfer of Shares.
12.1. Transfers of Ordinary Shares are subject to the prior written consent of the General Partner. The General

Partner will be entitled to withhold its consent to a proposed transfer (i) if the General Partner considers that the transfer

181039

L

U X E M B O U R G

would violate any applicable law, regulation or any term of the Articles; or (ii) if the General Partner considers the
transferee is not a Well-Informed Investor.

12.2. No transfer of Ordinary Shares will become effective unless and until the transferee agrees in writing to fully and

completely assume any outstanding obligations of the transferor in relation to the transferred Ordinary Shares (under
the relevant Subscription Agreement and agrees in writing to be bound by the terms of the Offering Memorandum and
the Articles, whereupon the transferor shall be released from (and shall bear no further liability for) such liabilities and
obligations.

12.3. Once the transferor has transferred its Ordinary Shares, such transferor shall have no further liability of any

nature under the Offering Memorandum or in respect of the Company or the relevant Compartment in relation to the
Ordinary Shares it has transferred.

12.4. Any transfer of registered Ordinary Shares shall be made by a written declaration of transfer to be inscribed in

the Register, dated and signed by the transferor and transferee, or by persons holding suitable powers of attorney to act
on their behalf, and in accordance with the rules on the assignment of claims laid down in article 1690 of the Civil Code.
The Company may accept and enter in the register of Shareholders a transfer on the basis of correspondence or other
documents recording the agreement between the transferor and the transferee.

12.5. The Management Share is exclusively and mandatorily transferable upon removal of the General Partner as per

Art. 20 9 below.

Art. 13. Initial Offering Period.
13.1. The initial offering period for each Compartment will be as provided for in the relevant appendix of the Offering

Memorandum relating to the relevant Compartment.

III. Management - Representation

Art. 14. Management.
14.1. The Company shall be managed by the General Partner in accordance with these Articles, the Offering Memo-

randum and any requirements of mandatory law. Unless otherwise provided by mandatory law, the Offering Memorandum
or  by  these  Articles,  the  General  Partner  shall  have  the  broadest  powers  to  perform  all  acts  of  administration  and
disposition of the Company provided that the authority of the General Partner shall be limited to the Company's assets.

14.2. Ordinary Shareholders may not participate or interfere in the management of the Company.
14.3. The General Partner shall only receive such remunerations as set out in the Offering Memorandum.
14.4. All powers not expressly reserved by mandatory law, the Offering Memorandum or by these Articles to the

general meeting of Shareholders shall be exercised by the General Partner.

14.5. Subject always to the restrictions contained in the Offering Memorandum, these Articles and mandatory law, the

General Partner shall have, in particular, the broadest powers to implement the investment strategy and borrowing
restrictions, as well as the course of conduct of the management and business affairs of the Company and to manage the
investments for the account of the Company with a view to achieving the investment strategy contained in the Offering
Memorandum provided always that the investments of the Company shall be restricted as described in the Offering
Memorandum.

14.6. The authority of the General Partner shall terminate automatically upon its resignation or removal from the

Company (in particular in accordance with Art. 20).

14.7. Any change in the management or replacement of the General Partner is subject to the agreement of the CSSF.

Art. 15. Representation.
15.1. The General Partner shall have complete discretion and full power, authority and right to represent and bind the

Company.

15.2. The Company shall be bound towards third parties by the signature of the General Partner or by the individual

or joint signatures of any other persons to whom authority shall have been delegated by the General Partner as the
General Partner shall determine in its discretion.

Art. 16. Delegation.
16.1. The General Partner may, from time to time and always subject that it remains ultimately responsible, appoint

such officers or agents of the Company which it reasonably considers necessary for the operation and management of
the Company, provided however that the Shareholders may not act on behalf of the Company without risking their limited
liability status.

16.2. The General Partner may, from time to time and always subject that it remains ultimately responsible, sub-delegate

its power to perform specific tasks to one or more ad hoc agent(s). In particular, the General Partner may, from time to
time, appoint one or more committees and delegate certain of its functions to such committees.

181040

L

U X E M B O U R G

Art. 17. Investment Manager.
17.1. The General Partner in carrying out its management functions in relation to each Compartment may delegate

the investment management of a relevant Compartment to one or more investment managers (each an “Investment
Manager”).

17.2. The Investment Manager's role may vary, as better specified in the Offering Memorandum, and may imply portfolio

management of the relevant Compartment,

Art. 18. Investment Advisor.
18.1. The Company may appoint an investment advisor in relation to each Compartment, as set out in the Offering

Memorandum to provide advisory services to the General Partner and the Investment Manager if any, including making
investment and divestment recommendations.

Art. 19. Conflicts of Interest.
19.1. Subject always to the restrictions contained in the Offering Memorandum, no transaction or other business

between the Company and any other company or entity shall be affected or invalidated by the fact that the General
Partner or any of the Shareholders or the shareholders, managers, agents, affiliates, personnel or officers of the General
Partner is interested in, or is a partner, shareholder, member, director, officer or employee of such other company or
entity.

19.2. Subject always to the restrictions contained in the Offering Memorandum, the General Partner and its share-

holders, managers, agents, affiliates, personnel or officers shall not by reason of an affiliation with another company or
entity as described in Art. 19.1 above be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect
to any transaction or other business of the Company.

Art. 20. Removal of the General Partner.
20.1. The General Partner may be removed by Ordinary Shareholders holding more than fifty per cent (50%) of the

Share Capital as a result of the General Partner's fraud, gross negligence, wilful misconduct, bad faith or reckless disregard
of its obligations and duties in each case as determined by a court of competent jurisdiction.

20.2. The General Partner shall, prior to the general meeting of the Shareholders approving the General Partner's

removal in accordance with Art. 20.3 below, have the right to organise and hold a forum within two (2) weeks from the
date of receipt of the notice of the intended removal for cause to address the issues raised in the notice of such removal
with all Ordinary Shareholders and/or to send its statement addressing the issues raised to all Ordinary Shareholders.
The Ordinary Shareholders undertake to duly consider the General Partner's arguments prior to exercising their res-
pective rights to vote on removal. The Ordinary Shareholders further undertake to duly consider whether an action for
removal is still justified in the event that the individual whose behaviour, act or omission giving rise to the cause for
removal asserted has been removed from all management and/or any advisory capacity with regard to the Company, as
the case may be, or respective court or other legal action has been commenced in order to effect such removal without
delay after receipt of the notice of the intended removal. The Ordinary Shareholders shall not bring an action for removal
if  such  remedial  action  taken  sufficiently  addresses  their  concerns  and  the  decision  that  such  remedial  action  is  not
satisfactory shall require the approval of Ordinary Shareholders between them holding at least fifty per cent (50%) of the
Share Capital and shall be communicated to the General Partner in writing without delay.

20.3. In the event that the General Partner shall be removed in accordance with the above, a general meeting of the

Shareholders shall be held to approve the removal and to appoint, subject to Art. 14.7 a new general partner in repla-
cement of the existing General Partner and to amend the Articles to refer to the said new general partner instead of the
existing General Partner. Such general meeting of the Shareholders shall, at first call, meet a quorum requirement of fifty
per cent (50%) of the total Shares issued. Should such quorum requirement not have been met at the first meeting, no
quorum will be required at a reconvened meeting having the same agenda as the first meeting. Decisions at both meetings
will require a majority of two thirds of the votes cast.

20.4. The General Partner shall not be entitled to any compensation for such termination.
The General Partner shall be required to transfer its Management Share to the new general partner at a price equal

to one euro (EUR 1).

IV. Shareholders

Art. 21. Liability of the Shareholders.
21.1. The Ordinary Shareholders shall only be liable up to the amount contributed by them to the Company.
21.2. The General Partner shall have unlimited and joint liability for the debts, liabilities and obligations of the Company.

Art. 22. General Meetings of Shareholders.
22.1.  The  general  meeting  of  shareholders  shall  represent  all  the  shareholders  of  the  Company.  It  shall  have  the

broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company, provided that, any resolution
of the general meeting of shareholders amending the Articles or creating rights or obligations vis-à-vis third parties must
be approved by the General Partner.

181041

L

U X E M B O U R G

22.2. The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg, either at the Company's registered

office or at any other location in Luxembourg, to be specified in the notice of the meeting, at 11.00 a.m. (Luxembourg
time) on the third Wednesday of April of each year provided that the first annual general meeting of shareholders shall
be held on the third Wednesday of April 2016. If this day is not a Business Day, the annual general meeting shall be held
on the next Business Day.

22.3. Other general meetings of Shareholders may be held at the place and on the date specified in the notice of

meeting.

22.4. General meetings of Shareholders shall be convened by the General Partner pursuant to a notice setting forth

the agenda and sent by registered letter at least eight (8) days prior to the meeting to each registered shareholder at the
shareholder's address recorded in the register of shareholders. The giving of such notice to registered shareholders need
not be justified to the meeting.

22.5. If all shareholders are present or represented and consider themselves as being duly convened and informed of

the agenda, the general meeting may take place without notice of meeting.

22.6. The General Partner may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders in order to attend

any meeting of shareholders.

22.7. Each share, whatever its value, shall provide entitlement to one vote. Fractions of shares do not give their holders

any voting right.

22.8. Unless otherwise provided for in these Articles the requirements for participation, the quorum and the majority

at each general meeting are those outlined in articles 67 and 67-1 of the 1915 Law.

22.9. Any resolution of a meeting of shareholders to the effect of amending these Articles must be passed with (i) a

presence quorum of fifty percent (50%) of the shares issued by the Company at the first call and, if not achieved, with no
quorum requirement for the second call and, (ii) the approval of a majority of at least two-thirds (2/3) of the votes validly
cast by the shareholders present or represented at the meeting and (iii) the consent of the General Partner.

22.10. In accordance with article 68 of the 1915 Law of any resolution of the general meeting of shareholders of the

Company, affecting the rights of the holders of shares of any Compartment, class or type vis-à-vis the rights of the holders
of shares of any other Compartment or Compartments, Class or Classes, type or types shall be subject to a resolution
of the general meeting of shareholders of such Compartment or Compartments, Class or Classes, type or types. The
resolutions, in order to be valid, must be adopted in compliance with the quorum and majority requirements referred
herein, with respect to each Compartment or Compartments, Class or Classes, type or types concerned.

Art. 23. General Meetings of the Compartments or in Class(es) of Shares.
23.1. The provisions of article 22 of these Articles shall apply, mutatis mutandis, to such general meetings.
23.2. Unless otherwise provided for by law, or these Articles, the resolutions of the general meeting of shareholders

of a Compartment or of a Class are passed by a simple majority vote of the shareholders present or represented.

Art. 24. Representation at General Meetings of the Shareholders.
24.1. Any Shareholder may be represented at a meeting of the Shareholders by another person (who does not need

to be a Shareholder) appointed as its proxy in writing (provided that telegram or facsimile shall be sufficient).

24.2. The General Partner may permit any Shareholder to participate in any meeting of Partners via telephone or video

conference or by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify,
hear and speak to each other. The participation in a meeting as set out in the previous sentence shall be deemed a
participation in person at such meeting.

Art. 25. Voting and Quorum.
25.1. Except as otherwise required by the 1915 Law or provided for in these Articles and the Offering Memorandum,

resolutions at a meeting of the Shareholders duly convened shall be adopted by a simple majority (i.e. more than fifty per
cent (50%)) of the votes present or represented and cast, regardless of the proportion of the Share Capital represented
at such meeting.

25.2. Each Shareholder may also vote by way of voting forms provided by the Company. These voting forms shall

contain the date and place of the meeting, the agenda of the meeting, the text of the proposed resolutions as well as for
each proposed resolution, three boxes allowing the respective Shareholder to vote in favour, against or abstain from
voting on the proposed resolution. The voting forms shall be sent by the Shareholders by mail, telegram, or facsimile to
the registered office of the Company. The Company shall only accept the voting forms which are received prior to the
time of the meeting specified in the convening notice. Voting forms which show neither a vote (in favour or against the
proposed resolutions) nor an abstention shall be void.

Expenses - Allocations and distributions

Art. 26. Costs and Expenses.
26.1. The Company shall bear such costs and expenses (including fees) as provided for in the Offering Memorandum.

181042

L

U X E M B O U R G

Art. 27. Allocations and Distributions.
27.1. The Shareholders meeting shall, upon proposal of the General Partner and within the time limits provided by the

Luxembourg laws and regulations, these Articles and the Offering Memorandum, determine how the profits and losses
of the Company shall be allocated and may declare, or may authorise the General Partner to declare, distributions.

27.2. All allocations of the Company's profits and losses and all distributions shall be made in accordance with the

provisions of the Offering Memorandum.

27.3. The General Partner shall be authorised to make interim distributions subject to the applicable law and the

Offering Memorandum.

27.4. No distributions will be made unless there is sufficient cash available, or if the Net Asset Value of the Company

would as a consequence of the distribution fall below the legal minimum of € 1,250,000 (as required by the SIF Law) or
if the General Partner believes, in good faith, that the distribution would put the Company in a position where it is unable
to meet any future obligations or contingencies.

27.5. Distributions may be paid in kind by contributing to Shareholders assets of the Company. Such distributions will

be subject to receipt of an auditor's report on the value of the assets being distributed.

Art. 28. Indemnification.
28.1. The Company shall indemnify and hold harmless out of the Company's assets the Indemnified Persons against

any and all liabilities, actions, proceedings, claims, costs, demands, damages and expenses (including legal fees) incurred
or threatened arising out of or in connection with or relating to or resulting from the Indemnified Person being or having
acted as a managing partner, general partner or manager in respect of the Company or arising in respect of or in connection
with any matter or other circumstance relating to or resulting from the exercise of its powers as a managing partner,
general partner or manager or from the provision of services to or in respect of the Company or under or pursuant to
any management agreement or other agreement relating to the Company or in respect of services as a Nominated
Director or member of the Investment Advisor or which otherwise arise in relation to the operation, business or activities
of the Company provided however that any Indemnified Person shall not be so indemnified with respect to any matter
resulting from their fraud, wilful misconduct, bad faith or reckless disregard for their obligations and duties in relation to
the Company or, save in the case of Indemnified Individuals, their gross negligence (provided that such gross negligence
has had a material adverse economic effect on the Shareholders or the Company), provided that no Indemnified Persons
shall be indemnified in respect of any matter for which such person may not, under mandatory Luxembourg law, be
indemnified.

“Indemnified Person” shall mean any of the members of the board of managers of the General Partner and each of the

officers, agents and employees of the Company and/or the General Partner to the extent directly involved in the business
of the relevant Compartment. “Indemnified Individual” shall mean any officer, director, shareholder, agent, member,
adviser, consultant, partner or employee of the General Partner, the Investment Adviser, any Affiliate of either of them,
or a Nominated Director or any duly appointed member of the Investment Advisor.

“Nominated Director” shall mean any person nominated by the Company or the General Partner, the Investment

Advisor or any Affiliate of either of them to be a director (or equivalent) of any company in which the Company holds
an investment

For the avoidance of doubt, the indemnities set out in Art. 28 shall continue in effect notwithstanding that the Indem-

nified Person shall have ceased to act as managing partner, general partner or manager or otherwise to provide services
to or in respect of the Company or to act in any of the capacities described above and shall continue in effect notwiths-
tanding the termination of the Company.

V. Valuation - Accounting

Art. 29. Valuation.
29.1. The net asset value of the shares in every Compartment, Class, type or Sub-Class of share of the Company, shall

be determined quarterly and expressed in the currency(ies) decided upon by the General Partner. The General Partner
shall decide the days by reference to which the assets of the Company or Compartments shall be valued (each a “Valuation
Day”) and the appropriate manner to communicate the net asset value per share, in accordance with the legislation in
force. All valuations shall be made on the basis of the fair value. Such value shall be determined as follows:

(a) the value of the illiquid debt securities is determined as the amortized cost less permanent diminution in value as

determined in good faith by and under the direction of the General Partner, unless there has been a recent trade in which
case it shall be valued at the value determined in said recent trade. Amortized cost involves valuing a security at its cost
and thereafter assuming a constant amortization to maturity of any discount or premium regardless of the impact of
fluctuating interest rates on the market value of the security;

(b) the value of the illiquid equities is determined as the cost less permanent diminution in value as determined in good

faith by and under the direction of the General Partner, unless there has been a recent trade in which case it shall be
valued at the value determined in said recent trade.

(c) the value of assets denominated in a currency other than Euro shall be determined by taking into account the rate

of exchange prevailing at the time of the determination of the Net Asset Value; and

181043

L

U X E M B O U R G

(d) liquid assets comprising cash, treasury bonds and regularly traded money market instruments will be valued at their

market value with interest accrued.

(e) the value of unlisted banking shares shall be the value as published by the bank whose shares are being valued at

the moment of publication of the bank's financial statements, said value shall be applicable for the next twelve (12) months
and the minutes of the annual General Meeting of Shareholders will be made available by the Company to the Shareholders;

(f) the book value of listed and not listed corporate bonds will be the cost of said corporate bonds;
(g) shares listed on a non-liquid market will be valued at the most recent trade price done by the Company unless

there has been no recent trade I which case they shall be valued at their cost.

(h) the General Partner, at its discretion, may authorize the use of other methods of valuation if it considers that such

methods would enable the valuation of any asset of the Company to be determined more accurately.

Subject to the provisions of the Offering Memorandum, the General Partner may apply other fair valuation principles

for the assets of the Company to the extent that, in its reasonable discretion, this is justified by circumstances or market
conditions subject to such other fair valuation principles being applied on a consistent basis.

29.2. The assets of the Company shall include (without limitation):
(a) all cash on hand or on deposit, including any interest accrued thereon;
(b) all bills and demand notes payable and accounts receivable (including proceeds of securities sold but not delivered);
(c) all shares, stock, debentures, debenture stocks, subscription rights, warrants, options and other securities, financial

instruments and similar assets owned or contracted for by the Company (provided that the Company may make adjust-
ments with regards to fluctuations in the market value of securities caused by trading ex-dividends, ex-rights, or by similar
practices);

(d) all stock dividends, cash dividends and cash distributions received by the Company to the extent information

thereon is reasonably available to the Company;

(e) all interest accrued on any interest-bearing assets owned by the Company except to the extent that the same is

included or reflected in the principal amount of such assets;

(f) the liquidation value of all contracts and options the Company has an open position in;
(g) the preliminary expenses of the Company insofar as the same have not been written off; and
(h) all other assets of any kind and nature including expenses paid in advance.
29.3. The liabilities of the Company shall include (without limitation):
(a) all loans, bills and accounts payable;
(b) all accrued interest on loans of the Company (including accrued fees for commitment for such loans);
(c) all accrued or payable expenses (including administrative expenses, custodian fees and any other agents' fees);
(d) all known liabilities, present and future, including all matured contractual obligations for payments of money or

property, including the amount of any unpaid dividends declared by the Company;

(e) an appropriate provision for future taxes based on capital and income on the accounting date, and other reserves

(if any) authorized and approved by the General Partner as well as such amount (if any) as the General Partner may
consider to be an appropriate allowance in respect of any contingent liabilities of the Company; and

(f) all other liabilities of the Company of whatsoever kind and nature assessed in accordance with Luxembourg generally

accepted accounting principles. In determining the amount of such liabilities the Company shall take into account all
expenses payable by the Company pursuant to these Articles or the Offering Memorandum. The Company may accrue
administrative and other expenses of a regular or recurring nature based on an estimated amount ratably for annual or
other periods.

29.4. The General Partner may suspend calculation of the Net Asset Value for:
(a) any period when, in the reasonable opinion of the General Partner, a fair valuation of the assets of the Company

is not practicable for reasons beyond the control of the Company; or

(b) any period when any of the principal stock exchanges on which investments of the Company are quoted are closed

(otherwise than for ordinary holidays), or during which dealings thereon are restricted or suspended; or

(c) the existence of any state of affairs which constitutes an emergency as a result of which valuation of assets owned

by the Company would be impractical; or

(d) any breakdown in, or restriction in the use of, the means of communication normally employed in determining the

price or value of any of the Investments or the currency price or values on any such stock exchange; or

(e) during any period when the Company is unable to repatriate funds for the purpose of making payments on the

redemption of the Ordinary Shares or during which any transfer of funds involved in the realisation or acquisition, of
investments or payments due on redemption of Ordinary Shares cannot in the opinion of the General Partner be effected
at normal rates of exchange; or

(f) when the General Partner so decides, provided all Shareholders are treated on an equal footing and all relevant

laws and regulations are applied (i) as soon as an extraordinary general meeting of Shareholders or a Compartment has
been convened for the purpose of deciding on the liquidation or dissolution or the merger or absorption of the Company

181044

L

U X E M B O U R G

or a Compartment and (ii) when the General Partner is empowered to decide on this matter, upon their decision to
liquidate or dissolve or merge or absorb a Compartment; or

(g) upon the publication of a notice convening a general meeting of Shareholders for the purpose of resolving upon

the winding-up of the Company.

The General Partner shall promptly notify all Shareholders of any suspension of the calculation of the Net Asset Value.
29.5. All valuation regulations and determinations shall be interpreted and applied in accordance with Lux GAAP.
29.6. For each Compartment, adequate provisions will be made for expenses incurred and due account will be taken

of any off-balance sheet liabilities in accordance with fair and prudent criteria.

29.7. For each Compartment and for each Class, the net asset value per share shall be calculated in the relevant

reference currency by dividing the net assets attributable to such Compartment or Class (which shall be equal to the
assets minus the liabilities attributable to such Compartment or Class) by the number of shares issued and in circulation
in such Compartment or Class; assets and liabilities expressed in foreign currencies shall be converted into the relevant
reference currency, based on the relevant exchange rates.

29.8. The Company's net assets shall be equal to the sum of the net assets of all its Compartments.
29.9. In the absence of bad faith, gross negligence or manifest error, every decision in calculating the Net Asset Value

taken by the General Partner or by any other entity which the General Partner may appoint for the purpose of calculating
the Net Asset Value, shall be final and binding on the Company and on its present, past or future Shareholders, subject
to the year end audit by the auditor of the Company being a réviseur d'entreprises agréé.

Art. 30. Allocation of assets and Liabilities among the Compartments.
30.1. For the purpose of allocating the assets and liabilities between the Compartments, the General Partner shall

establish a portfolio of assets for each Compartment in the following manner:

- the proceeds from the issue of each share of each Compartment are to be applied in the books of the Company to

the portfolio of assets established for that Compartment and the assets and liabilities and income and expenditure attri-
butable thereto are applied to such portfolio subject to the following provisions;

- where any asset is derived from another asset, such derivative asset is applied in the books of the Company to the

same portfolio as the asset from which it was derived and on each revaluation of an asset, the increase or diminution in
value is applied to the relevant portfolio;

- where the Company incurs a liability which relates to any asset of a particular portfolio or to any action taken in

connection with an asset of a particular portfolio, such liability is allocated to the relevant portfolio;

- in the case where any asset or liability of the Company cannot be considered as being attributable to a particular

portfolio, such asset or liability is allocated to all the portfolios in equal parts or, if the amounts so justify, pro rata to the
net asset values of the relevant Compartments;

- upon the payment of dividends to the holders of shares in any Compartment, the net asset value of such Compartment

shall be reduced by the amount of such dividends.

Art. 31. Financial Year and Accounting.
31.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year

provided that the first fiscal year of the Company ends on December 31, 2015.

31.2. Within the time periods required by law, the financial statements of the Company shall be prepared and audited

in accordance with the provisions of Lux GAAP, the 1915 Law and the SIF Law.

Art. 32. Réviseurs d'entreprises.
32.1. The operations of the Company shall be supervised by one approved statutory auditor (réviseur d'entreprise

agréé) who shall satisfy the requirements of Luxembourg law as to professional experience and who shall carry out the
duties prescribed by the SIF Law.

32.2. The auditor shall be appointed by resolution of the general meeting of Shareholders and continue to carry out

its duties until its successor is appointed.

VI. Term - Dissolution - Liquidation

Art. 33. Term of the Company.
33.1. The Company or particular Compartment may be dissolved at any time, upon proposition by the General Partner,

by a resolution of the general meeting of Shareholders pursuant to Art. 22.9. or particular Compartment pursuant to Art
23.

33.2. Notwithstanding any other provisions of these Articles, and subject to the ninety (90) days waiting period referred

to below, the Company shall dissolve upon the occurrence of any of the following events:

(a) dissolution of the General Partner;
(b) commencement of insolvency proceedings over the assets of the General Partner or rejection of a petition to

commence such proceedings for lack of assets; or

(c) removal of the General Partner from the Company;

181045

L

U X E M B O U R G

provided that the Company shall not terminate if, within ninety (90) days after such an event, Ordinary Shareholders

holding at least seventy five per cent (75%) of the Share Capital elect to continue the business of the Company and to
appoint a successor general partner (subject always to Art. 14.7).

33.3. Each Compartment may be separately liquidated without such separate liquidation resulting in the liquidation of

another Compartment. Only the liquidation of the last remaining Compartment of the Company will result in the final
liquidation of the Company.

Art. 34. Liquidation.
34.1. The liquidation of the Company or of a Compartment shall be carried out by one or several liquidators, who

may be physical persons or legal entities, approved by the CSSF and appointed by the general meeting of Shareholders
of the Company or of the relevant Compartment which shall determine their powers and their compensation.

34.2. The liquidation will take place in accordance with applicable Luxembourg law. The net proceeds of the liquidation

will be distributed to shareholders in proportion to their rights.

34.3. At the end of the liquidation process of the Company or of the relevant Compartment, any amounts that have

not been claimed by the shareholders will be paid into the caisse de consignation, which keep them available for the
benefit of the relevant shareholders during the duration provided for by law. After this period, the balance will return to
the State of Luxembourg.

VII. Miscellaneous

Art. 35. Governing Law.
35.1. In respect of all matters not governed by these Articles the parties shall refer to the provisions of the 1915 Law

and the relevant law and regulations applicable to Luxembourg undertakings for collective investment, notably the SIF
Law.

VIII. Definitions

In these Articles, the following terms shall have the following meaning unless the context requires otherwise:

“1915 Law”

the meaning given in Art. 1.1.

“Affiliate”

in relation to any undertaking (“U”), a parent undertaking of U, a subsidiary undertaking
of U, a subsidiary undertaking of a parent undertaking of U or a parent undertaking of a
subsidiary undertaking of U OR in relation to any body corporate (“C”), a holding company
of C, a subsidiary of C, a subsidiary of a holding company of C or a holding company of a
subsidiary of C, provided however that a portfolio company shall not be deemed to be an
Affiliate of the General Partner by reason only of an investment by the Company in such
portfolio company.

“Business Day”

a day (not being a Saturday or Sunday or a public holiday) on which banks are generally
open for non-automated business in Luxembourg.

“Class(es)”

the meaning given in Art. 5.5.

“Company”

the meaning given in Art. 1.1.

“Compartment”

a compartment of the Company corresponding to a distinct part of the assets and liabilities
of the Company.

“CSSF”

shall mean the Luxembourg financial supervisory authority (commission de surveillance du
secteur financier).

“General Partner”

shall mean Kant Capital S.à r.l., or any replacement as the managing general partner (associé
gérant commandité) of the Company from time to time.

“Indemnified Individual”

The meaning given in Art. 28.1

“Indemnified Person”

The meaning given in Art. 28.1

“Investment Advisor”

shall mean the investment advisor appointed by the Company and referred to in the
Offering Memorandum.

“Lux GAAP”

shall mean Luxembourg Generally Accepted Accounting Principles.

“Management Fee”

shall mean the fee payable by the Company to the General Partner as more particularly
described in the Offering Memorandum.

“Management Share”

the meaning given in Art. 5.2.

“Net Asset Value”

shall mean the value of the assets less the value of the liabilities applicable to a particular
Compartment, class, type or Sub-Class of shares which shall be determined according to
the provisions in Art. 29.1 29.9.

“Nominated Director”

the meaning given in Art. 28.1

“Offering Memorandum” shall mean the offering document of the Company as approved by the CSSF as same may

be amended from time to time.

“Ordinary Shares”

the meaning given in Art. 5.2

181046

L

U X E M B O U R G

“Ordinary Shareholders” shall mean the limited shareholders, holders of Ordinary Shares.
“Register”

the meaning given in Art. 8.2

“Registrar and Transfer
Agent”

the meaning given in Art. 8.2.

“Shares”

the meaning given in Art. 5.3

“Share Capital”

the meaning given in Art. 5.1

“Shareholders”

shall mean the General Partner and the Ordinary Shareholders.

“SIF Law”

shall mean the Luxembourg Law of 13 February 2007 on Specialised Investment Funds, as
amended.

“Subscription Agreement” the meaning given in Art. 7.1.
“Sub-Class(es)”

the meaning given in Art. 5.5.

“Valuation Day”

the meaning given in Art. 29.1.

“Well-Informed Investor” has the meaning ascribed to it by the SIF Law, and includes: a) institutional investors; b)

professional investors; and c) any other well-informed investor who fulfils the following
conditions:
(i) declares in writing that he adheres to the status of well-informed investor and invests
a minimum of one hundred and twenty five thousand euros (EUR 125,000) in the Company;
or (ii) declares in writing that he adheres to the status of well-informed investor and
provides an assessment made by a credit institution within the meaning of the Directive
2006/48/CE, by an investment firm within the meaning of the Directive 2004/39/CE or by
a management company within the meaning of the Directive 2009/65/CE, certifying his
expertise, his experience and his knowledge in adequately appraising an investment in the
Company.

<i>Transitional dispositions

The first financial year of the Company shall begin on the date of its incorporation and shall terminate on 31 December

2015.

The first annual general meeting of Shareholders of the Company shall be held in 2016.

<i>Initial share capital - Subscription and payment

The initial share capital is fixed at thirty-one thousand euros (EUR 31,000.-) represented by:
1. one (1) management share without par value, to be subscribed at an initial subscription price of one thousand euros

(EUR 1,000); and

2. thirty (30) ordinary shares, without par value, to be subscribed at an initial subscription price of one thousand euros

(EUR 1,000) each.

The share capital of the Company is subscribed as follows:

Name of Subscriber

Number of subscribed shares

Kant Capital S.à r.l., prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Management Share
Mr Girolamo Stabile, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Ordinary Shares, divided into:

- 10 Ordinary Shares in the Sub-Fund
“Kant Capital Fund S.C.A. SICAV-SIF: Unit 1”;
- 10 Ordinary Shares in the Sub-Fund
“Kant Capital Fund S.C.A. SICAV-SIF: Unit 2”; and
- 10 Ordinary Shares in the Sub-Fund
“Kant Capital Fund S.C.A. SICAV-SIF: Unit 3”;

All the shares of the Company so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of thirty-one thousand euros

(EUR 31,000.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the officiating notary.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately 3,000.- Euro.

<i>General meeting of the shareholders

The above named persons, representing the entire subscribed share capital and considering themselves as validly

convened, have immediately proceeded to hold a general meeting of shareholders. After verification of the due consti-
tution of the meeting, the meeting has adopted the following resolutions by unanimous vote, including the vote of the
General Partner:

1. The registered office of the Company shall be at 33A, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy

of Luxembourg.

181047

L

U X E M B O U R G

2. Deloitte Audit S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and existing

under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 560, rue de Neudorf, L-2220, Luxem-
bourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 67.895, is appointed as
independent auditor of the Company, until the end of the general meeting of shareholders called to deliberate upon the
annual accounts of the Company for the financial year ending on 2015.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing parties, known to the notary by their name, first name, civil status

and residence, the said appearing parties signed together with the notary the present deed.

Signé: Courtois, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 23 octobre 2014. Relation: EAC/2014/14340. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur ff.

 (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2014176232/689.
(140202194) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2014.

F.L.B.B., Fédération Luxembourgeoise de Basketball, Association sans but lucratif.

Siège social: L-8009 Strassen, 3, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg F 2.301.

I. Dispositions générales

ST-1. Dénomination. L'association est dénommée "Fédération Luxembourgeoise de Basketball", en abrégé «FLBB»,

association sans but lucratif (ci-après «la Fédération»).

La FLBB est affiliée à la Fédération Internationale de Basketball (FIBA), au sein de laquelle elle fait partie de la zone

FIBA-Europe ainsi qu’au Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois (C.O.S.L.).

ST-2. Siège. L’association a son siège à L-8009 Strassen, 3, route d’Arlon.

ST-3. Durée. La durée de l’association est illimitée.

ST-4. Objet. L'association a pour objet:
1. la propagation de la pratique du jeu de basketball, sous quelque forme que ce soit;
2. de rassembler en son sein tous les clubs pratiquant le basketball dans la zone géographique de la Fédération (ci-

après «les Clubs») et de favoriser la création de nouveaux clubs;

3. l’organisation de compétitions sous quelque forme que ce soit entre les Clubs;
4. l’organisation, la gestion et le développement des équipes nationales et des équipes d’élite et la participation avec

ces équipes à des compétitions internationales;

5. d’encourager et de cultiver l’esprit sportif et le fair-play de ses membres;
6. de représenter le basketball national auprès des autorités publiques et des organisations et associations nationales

et internationales.

La Fédération s'interdit toute activité politique ou confessionnelle.
Elle peut en outre réaliser son objet, directement ou indirectement, par la création, la gestion, l’organisation, l’entretien

et la direction des oeuvres poursuivant le même but. Elle peut prêter tous concours et s'intéresser de toute manière à
toutes oeuvres sans but lucratif ayant un objet identique et analogue au sien.

ST-5. Organes. Les organes de la Fédération sont les suivants:
1. l’Assemblée Générale
2. le Conseil d’Administration
3. les Juridictions Fédérales, à savoir le Tribunal Fédéral et le Conseil Fédéral d’Appel
La composition et les attributions de l’Assemblée Générale, du Conseil d’Administration et des Juridictions Fédérales

sont fixées par les présents Statuts.

II. Membres de la fédération

ST-6. Membres. La Fédération se compose des membres suivants (ci-après «les Membres»):
1. de Clubs, quelque soit leur forme juridique,
2. de sections corporatives,
3. d’autres entités associatives poursuivant le même objet social que la FLBB,
4. de personnes physiques à titre individuel (membres neutres) et

181048

L

U X E M B O U R G

5. de personnes physiques qui se sont distinguées dans leur engagement pour le basketball (membres honoraires).
Les Clubs sont les associés au sens de la Loi du 21 avril 1928 sur les associations et fondations sans but lucratif, telle

que modifiée.

Les Clubs s’interdisent la poursuite de tout but lucratif.

ST-7. Affiliation. Le nombre des Clubs est illimité; il ne peut cependant être inférieur à trois.
Seuls des Clubs pratiquant le basketball et qui poursuivent un but non lucratif peuvent être admis comme membres

de la Fédération.

Par l’affiliation à la Fédération, les Membres se conforment aux présents Statuts, aux Règlements Administratifs, aux

Règlements de jeux, aux Circulaires et aux décisions de la Fédération et peuvent encourir des sanctions disciplinaires en
cas de non observation de ces règles.

Par l’affiliation à la Fédération, les Membres se conformeront également aux réglementations et obligations que la FLBB

a contractées et contractera à l’occasion de son affiliation à des associations et organisations nationales et internationales
telles que notamment les statuts, règlements et compétitions sportives de la FIBA, de FIBA-Europe et du COSL.

La procédure d’affiliation est prévue par le règlement administratif.
L'admission des Clubs qui désirent s'affilier à la FLBB est prononcée définitivement par l’Assemblée Générale qui suit

immédiatement la demande d’affiliation.

L’admission des membres neutres se fait sur simple décision du Conseil d’Administration qui leur délivrera une licence

de membre neutre.

ST-8. Cotisation et contribution financière. La cotisation annuelle des Membres ne peut pas dépasser le montant de

mille euros (1.000 €). Elle est fixée annuellement par l’Assemblée Générale ordinaire.

Chaque  Club  dispose  d'un  compte  auprès  de  la  Fédération  qui  doit  être  approvisionné  de  manière  à  couvrir  les

dépenses courantes du Club conformément aux dispositions du règlement financier.

ST-9. Licences. Les Clubs sont obligés de faire établir par la Fédération une licence pour tous leurs membres actifs (ci-

après «les Licenciés»). Sont à considérer comme membres actifs les membres de l’organe de direction et des commissions
consultatives, les entraîneurs, les managers, les arbitres et les autres officiels ainsi que les joueurs et joueuses de toutes
les catégories d’âge.

En principe, tout membre actif participant aux compétions de la FLBB ne peut être licencié simultanément que pour

un seul club, luxembourgeois ou étranger. Par dérogation à cette règle générale, la FLBB pourra accorder des doubles
licences aux Licenciés au départ de clubs luxembourgeois participant à la fois aux compétitions nationales et à des com-
pétitions non nationales.

Par la demande d’une licence, les Licenciés se conforment aux présents Statuts, aux Règlements Administratifs, aux

Règlements de jeux, aux Circulaires et aux décisions de la Fédération et peuvent encourir des sanctions disciplinaires en
cas de violation de ces règles.

La Fédération et ses Membres respectent le traitement égal entre licenciés féminins et licenciés masculins.

ST-10. Perte de la qualité de membre. La qualité de membre de la Fédération se perd par:
1. la démission,
2. l’exclusion,
3. la non-participation aux compétitions officielles de la FLBB pendant trois saisons consécutives, ou
4. la dissolution du Club.
Le Membre démissionnaire ou exclu n’a aucun droit sur le fonds social de la Fédération et ne peut exiger le rem-

boursement de sa cotisation versée.

ST-11. Démission d’un Membre. La démission datée et signée du Membre est à adresser par lettre recommandée à la

Fédération.

Une démission ne peut devenir effective que si le Membre démissionnaire a satisfait à toutes ses obligations financières

à l’égard de la Fédération.

ST-12. Exclusion. L'exclusion d’un Membre ne peut être prononcée que dans un des cas suivants:
1. non-paiement de dettes envers la Fédération, dans un délai de six mois à compter de l’envoi d’une mise en demeure

écrite par la Fédération;

2. infraction grave à la loi, aux présents Statuts, aux Règlements administratifs et aux Circulaires du Conseil d’Admi-

nistration;

3. agissements contraires aux intérêts du basketball et de la FLBB.
L’exclusion ne peut être prononcée que par l’Assemblée Générale statuant à la majorité des deux tiers des voix. La

procédure d’exclusion est prévue par Règlement administratif.

ST-13. Basketball corporatif. La FLBB reconnaît les clubs de Basketball corporatif issus des administrations, secteur

des services, secteurs industriels, secteur agricole, grandes entreprises, petites et moyennes entreprises, firmes privées,

181049

L

U X E M B O U R G

entreprises coopératives etc., établis au Grand-Duché, qui organisent pour leurs membres une activité sportive confor-
mément aux Statuts et Règlement s de la FLBB et du BASCOL.

En cas d'infraction à ces Statuts et Règlements, les membres de ces Clubs sont justiciables des tribunaux de la FLBB.
Les sections corporatives n'ont qu'une voix consultative lors des Assemblées Générales de la FLBB.

III. Assemblée générale

ST-14. Composition de l’Assemblée Générale. Les Assemblées Générales se composent de tous les Clubs de la Fé-

dération, chacun représenté par deux Licenciés délégués par écrit à cet effet. Les membres du Conseil d’Administration
et des Juridictions Fédérales ne peuvent représenter le Club auprès duquel ils sont licenciés.

La présence des Clubs et du Conseil d’Administration aux Assemblées Générales est obligatoire, sauf motif grave.
Les Membres autres que les Clubs peuvent assister aux Assemblées Générales. Ils n’y ont qu’une voix consultative.

ST-15. Pouvoirs de l’Assemblée Générale. Les Assemblées Générales ont le pouvoir:
1. de désigner les membres du Conseil d’Administration et des Juridictions Fédérales et de révoquer ces membres;
2. de modifier les Statuts;
3. d’arrêter et de modifier les Règlements administratifs;
4. de définir le périmètre géographique de la Fédération;
5. de statuer sur l’affiliation définitive de nouveaux Clubs;
6. de se prononcer sur l’exclusion d’un Membre;
7. de fixer la cotisation annuelle pour les Clubs;
8. d’approuver les comptes de la Fédération pour l’exercice écoulé ainsi que du budget rectifié pour l’exercice en

cours et de voter le budget annuel pour l’exercice suivant;

9. de désigner les vérificateurs des comptes pour l’exercice suivant;
10. d’approuver ou de refuser les rapports du Conseil d’Administration et des Commissions ainsi que des Juridictions

Fédérales;

11. de donner décharge aux membres du Conseil d’Administration et aux réviseurs;
12. de voter des motions;
13. d’octroyer la qualité de membre honoraire;
14. de décider la dissolution de la Fédération et décider de l’affectation de l’actif social en cas de dissolution.

ST-16. Tenue des Assemblées Générales. L'Assemblée Générale ordinaire de la Fédération se tient endéans les trois

premiers mois de l’année sociale soit au plus tard le dernier jour du mois de septembre de chaque année.

Le Conseil d’Administration a le droit de convoquer à d'autres époques des Assemblées Générales extraordinaires.

Il est tenu de le faire dans un délai d'un mois si un cinquième des Clubs en fait la demande en indiquant les points à mettre
sur l’ordre du jour.

La date, l’heure et l’endroit des Assemblées Générales ordinaires sont portés à la connaissance des intéressés par

publication au Bulletin Officiel de la Fédération au moins deux mois à l’avance. Pour motifs graves dûment motivés et
pour les Assemblées Générales extraordinaires, ce délai peut être ramené à un mois. Le Conseil d’Administration com-
munique dans tous les cas également un ordre du jour provisoire.

Les Clubs peuvent demander au plus tard trois semaines avant la date d’une Assemblée Générale l’inclusion d’un ou

de plusieurs points à l’ordre du jour de cette Assemblée, à condition que la demande soit signée par un nombre de Clubs
égal au vingtième de la dernière liste annuelle. Les Clubs doivent fournir les documents en relation avec les points mis à
l’ordre du jour à leur demande.

La convocation des Membres est faite par le Conseil d’Administration au moins quinze jours avant la date fixée. La

convocation aux Assemblées Générales ordinaires contiendra l’ordre du jour définitif, le bilan de l’année écoulée et le
projet du budget pour l’exercice suivant, les rapports d'activité du Conseil d’Administration et des Commissions ainsi
que les documents en relation avec les points de l’ordre du jour. La convocation aux Assemblées Générales extraordi-
naires comportera l’ordre du jour définitif ainsi que la documentation y afférente.

ST-17. Déroulement des Assemblées Générales. La participation aux Assemblées Générales est obligatoire pour les

Clubs sous peine de sanction à prévoir par Règlement Administratif.

Sans préjudice des quorums particuliers prévus aux présents Statuts et par la loi, les Assemblées Générales sont en

nombre si la majorité des Clubs est présente.

Les décisions des Assemblées Générales sont souveraines. Sans préjudice de majorités qualifiées plus élevées prévues

aux présents Statuts et par la loi, elles sont prises à la majorité relative des voix des Clubs présents.

Les votes par appel nominal se font par ordre alphabétique des Clubs présents, à commencer par une lettre tirée au

sort au début de chaque Assemblée Générale. Le vote est secret si la demande en est faite par cinq Clubs au moins.

181050

L

U X E M B O U R G

Les modifications aux Statuts, la dissolution de la Fédération et l’exclusion d’un Membre se font dans le respect des

quorums et des conditions de majorité prévus par la Loi du 21 avril 1928 sur les associations et fondations sans but
lucratif, telle que modifiée.

Aucune résolution ne peut être prise en dehors de l’ordre du jour tel qu’indiqué dans la convocation à l’Assemblée

Générale ordinaire ou extraordinaire.

Le nombre de voix dont dispose un Club est déterminé par le nombre des équipes qui ont disputé et terminé le

championnat précédent.

En cas de fusion de Clubs le nombre de voix dont dispose le Club nouvellement admis par l’Assemblée Générale est,

pour la première Assemblée Générale Ordinaire, égal au nombre d’équipes auquel chacun des deux Clubs fusionnés aurait
eu droit avant la fusion conformément au paragraphe précédent.

N'a pas droit au vote le Club qui n'est pas représenté par un de ses Licenciés dûment mandaté.
Les Clubs suspendus ainsi que ceux qui n'ont pas payé leurs dettes envers la Fédération n'ont pas droit au vote. Le

paiement des dettes doit parvenir à la Fédération au plus tard 15 jours avant la date de l’assemblée générale ordinaire. A
défaut de paiement endéans ce délai, le droit de vote du/des Club(s) concerné(s) reste suspendu jusqu’à la prochaine
assemblée  générale  ordinaire.  Le(s)  Club(s)  concerné(s)  recouvre(nt)  leur  droit  de  vote  à  cette  assemblée  générale
ordinaire, à condition d’avoir payé l’intégralité de leurs dettes au plus tard 15 jours avant la date de cette assemblée
générale ordinaire. Nonobstant la suspension de leur droit de vote, le(s) club(s) n’est/ne sont pas dispensé(s) de l’assis-
tance aux Assemblées Générales ordinaire et extraordinaire.

ST-18. Procès-verbaux des Assemblées Générales. Les résolutions prises par les Assemblées Générales sont consi-

gnées sous forme de procès-verbal signé par le président de l’Assemblée et par les membres du bureau de vote.

Dans les 2 mois de l’Assemblée Générale, une copie des procès-verbaux des Assemblées Générales est adressée par

le Conseil d’Administration aux Clubs pour remarques et annotations. Celles-ci doivent être transmises au Conseil d’Ad-
ministration dans les quinze jours de l’envoi de la copie du procès-verbal.

Le procès-verbal définitif sera arrêté par le Conseil d’Administration.
Les résolutions de l’Assemblée Générale entrent en vigueur le deuxième jour qui suit leur publication au Bulletin

Officiel de la Fédération, sauf le cas où l’Assemblée Générale a fixé une date d’entrée en vigueur plus lointaine.

Les résolutions qui intéressent les tiers sont publiées par extrait au Bulletin Officiel de la Fédération et au Registre de

Commerce et des Sociétés dans les cas requis par la loi.

IV. Conseil d’administration

ST-19. Composition du Conseil d’Administration. La Fédération est administrée par un Conseil d’Administration, élu

par l’Assemblée Générale.

La durée du mandat d’administrateur est de deux ans. Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le Conseil d’Administration de la Fédération se compose des membres suivants:
1. d'un président;
2. d'un vice-président, responsable du développement international;
3. d’un vice-président, responsable du développement national;
4. d'un secrétaire général;
5. d'un ou de plusieurs secrétaires généraux adjoints;
6. d’un administrateur responsable des statuts et des affaires judiciaires, président de la Commission des Statuts;
7. d'un administrateur responsable du budget et des finances, président de la Commission des Finances et du Budget;
8. d’un administrateur, responsable des cadres hommes, co-président de la Commission Sportive;
9. d’un administrateur responsable des cadres dames, co-président de la Commission Sportive;
10. d’un administrateur responsable des cadres jeunes, vice-président de la Commission Sportive;
11. d'un administrateur, responsable de l’organisation technique, président de la Commission Technique;
12. d’un administrateur, adjoint au responsable de l’organisation technique;
13. d’un administrateur, responsable des arbitres, président de la Commission des Arbitres;
14. d'un administrateur, responsable de la Nationale 1, Dames et Hommes, qui doit obligatoirement être choisi dans

un Club engagé dans cette compétition;

15. d'un administrateur, responsable des Nationales 2 et 3, Dames et Hommes, qui doit obligatoirement être choisi

dans un Club engagé dans cette compétition;

16. d'un administrateur, responsable des compétitions jeunes et sports-loisirs masculins et féminins;
17. d'un administrateur, responsable du marketing, de la promotion et des événements;
18. d'un administrateur, responsable des relations avec les médias;
19. d’un ou de plusieurs administrateurs sans attributions particulières.
Le nombre total d’administrateurs ne peut en aucun cas dépasser le nombre de 21 personnes.

181051

L

U X E M B O U R G

Le Conseil d’Administration ne peut pas compter plus de trois Licenciés d’un même Club.

ST-20. Pouvoirs du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration dispose des pouvoirs pour accomplir les

actes nécessaires ou utiles pour l’administration et la gestion des affaires de la Fédération et pour la réalisation de l’objet
de celle-ci.

Il représente la Fédération dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.
Tout ce qui n’est pas expressément réservé par les présents Statuts ou par la Loi à l’Assemblée Générale est de la

compétence du Conseil d’Administration.

Les attributions du Conseil d’Administration comprennent notamment:
1. l’administration générale de la Fédération et la gestion des comptes;
2. l’élaboration, avec l’aide des Commissions, de Circulaires à destination des Membres et Licenciés;
3. l’établissement du budget;
4. la préparation, avec l’aide des commissions, de projets de Règlements administratifs;
5. les relations avec les autorités sportives et publiques nationales et internationales, telles que l’adhésion à des orga-

nisations et associations nationales et internationales;

6. l’instruction des dossiers d’affiliation des nouveaux Clubs;
7. l’admission de Membres neutres et la proposition de Membres honoraires;
8. la gestion des licences;
9. l’arbitrage en matière de transferts;
10. la surveillance du contrôle médical des joueurs;
11. l’organisation des championnats, des coupes, des rencontres et tournois internationaux;
12.  l’adoption  du  calendrier  des  compétitions  et  la  fixation  des  matchs  en  fonction  des  besoins  et  exigences  des

engagements de la FLBB au niveau national et international;

13. la nomination des entraîneurs nationaux et la gestion des cadres nationaux;
14. la désignation de membres non-élus des commissions;
15. la mise en place, la gestion et le contrôle des commissions;
16. la création de groupes de travail ad-hoc, dont il fixera la mission, la composition et le fonctionnement;
17. la création de structures d’organisation spécifiques adaptées pour la prise en charge d’objectifs spécifiques fixés

par le Conseil d’Administration de la FLBB;

18. la représentation de la Fédération en justice;
19. l’octroi des récompenses honorifiques;
20. l’arbitrage et la conciliation entre Membres de la Fédération;
21. les décisions nécessaires ou utiles pour la bonne application des Statuts et des Règlements Administratifs.
Si les besoins l’exigent, le Conseil d’Administration peut constituer en son sein un Comité exécutif chargé d'évacuer

les affaires courantes. La composition et le fonctionnement de ce Comité exécutif sont arrêtés par le Conseil d’Admi-
nistration.

Le Conseil d’Administration peut également, sous sa responsabilité, déléguer certains de ses pouvoirs à l’un de ses

Membres, à un tiers ou à une Commission au sens de l’article ST-22. Une telle délégation doit être écrite et publiée au
Bulletin Officiel de la Fédération.

Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l’association. Leur

responsabilité se limite à l’exécution du mandat qu’ils ont reçu et aux fautes commises dans leur gestion.

ST-21. Déroulement des réunions du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration est en nombre si la ma-

jorité des administrateurs est présente.

Le  président  dirige  les  travaux  du  Conseil  d’Administration.  En  cas  d’empêchement  il  sera  remplacé  par  un  vice-

président, et en leur absence par l’administrateur le plus ancien en rang. Les travaux et les délibérations du Conseil
d’Administration sont confidentiels, sauf stipulations prévues à l’article ST-24 ci-après.

Les décisions sont prises à la majorité relative des administrateurs présents. En cas de partage des voix, celle du

président dirigeant la séance est décisive.

Le vote secret est obligatoire pour toute question concernant des personnes.
Un administrateur qui est absent sans excuse à trois séances consécutives ou à cinq séances non-consécutives est

considéré de droit comme démissionnaire.

ST-22. Commissions. Au niveau du Conseil d’Administration existent au moins les Commissions permanentes suivan-

tes:

- la Commission Technique;
- la Commission Sportive;

181052

L

U X E M B O U R G

- la Commission des Arbitres.
Le Conseil d’Administration peut à tout moment mettre en place d’autres Commissions qu’il juge appropriées.
La composition et les attributions des Commissions sont fixées par Règlement administratif.
Une personne ne peut cumuler des fonctions dans plus de deux Commissions de la Fédération. Cette prescription ne

s’applique pas à la Commission des Statuts.

ST-23. Conflits d’intérêts. Une personne ne peut prendre part ni aux délibérations, ni au vote du Conseil d’Adminis-

tration ou d’une Commission qui décide d'une affaire litigieuse dans laquelle son club ou lui-même, un parent ou allié est
mis en cause. Elle doit informer dans ce cas le Conseil d’Administration ou la Commission de l’existence du conflit
d’intérêts et du respect des modalités du présent article qui doit être mentionné dans le procès-verbal de la réunion.

ST-24. Circulaires et procès-verbaux. Les décisions prises lors des réunions du Conseil d’Administration et des Com-

missions (ci-après «les Décisions») sont consignées sous forme de procès-verbaux.

Les circulaires émises par le Conseil d’Administration sont obligatoires pour tous les Membres et Licenciés (ci-après

«les Circulaires»).

Le Conseil d’Administration peut, sous sa responsabilité, déléguer à certaines Commissions le pouvoir d’émettre des

Circulaires sur des points de nature technique. Ces Circulaires seront signées par le président de la Commission con-
cernée et ont la même valeur que les Circulaires émises par le Conseil d’Administration lui-même.

Toute délégation en matière de Circulaires est publiée au Bulletin Officiel de la Fédération.
Les Décisions et Circulaires sont publiées au Bulletin Officiel de la Fédération. Elles peuvent être notifiées aux intéressés

par écrit (lettre, fax ou mail). Elles sont applicables dès leur publication ou notification.

ST-25. Pouvoirs de signature. La Fédération est engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe du Président du

Conseil d’Administration et du Secrétaire Général ou d’un des deux ensemble avec un administrateur.

ST-26. Vacance de poste. Le Conseil d’Administration peut pourvoir aux vacances de poste qui se produisent entre

deux séances de l’Assemblée Générale au sein du Conseil d’Administration en désignant un ou plusieurs administrateur
(s) existant(s) comme responsable(s) du/des ressort(s) affecté(s) par la/les vacance(s) de poste.

Il peut de même entre deux séances de l’Assemblée Générale pourvoir à une vacance de poste en cooptant un nouveau

membre, qui doit être licencié ou membre neutre de la Fédération. Le membre coopté poursuit le terme du mandat du
membre qu’il remplace, sa cooptation devant, par ailleurs, être soumise à ratification de la première Assemblée Générale
suivant ladite cooptation.

V. Juridictions fédérales

ST-27. Composition des Juridictions Fédérales. Le Tribunal Fédéral et le Conseil d’Appel se composent de trois mem-

bres effectifs, dont de préférence au moins un juriste, et de 5 membres suppléants élus par l’Assemblée Générale pour
un an.

Ni le Tribunal Fédéral ni le Conseil d’Appel ne peut compter en son sein plus d’un membre d`un même Club. Un

joueur ou arbitre actif ne peut être membre des Juridictions Fédérales.

Les membres du Tribunal Fédéral et du Conseil d'Appel choisissent eux-mêmes leurs présidents, et le cas échéant,

leurs secrétaires parmi leurs membres. Toutefois un secrétaire et un secrétaire-suppléant, désignés par le Conseil d’Ad-
ministration, peuvent être adjoints à ces organes; dans ce cas, ceux-ci ne peuvent prendre part ni aux délibérations ni aux
votes.

ST-28. Attributions du Tribunal Fédéral et du Conseil d’Appel. Le Tribunal Fédéral a dans ses attributions en premier

ressort des infractions aux Statuts, Règlements Administratifs, Circulaires et Décisions commises par les Membres et les
Licenciés, ainsi que des litiges et interprétations en relation avec les Statuts, Règlements Administratifs, Circulaires et
Décisions.

Le Tribunal Fédéral a aussi dans ses attributions les recours contre les arbitrages et conciliations rendus par le Conseil

d’Administration.

Le Conseil d’Appel est saisi des appels contre les décisions du Tribunal Fédéral. Il statue toujours en dernière instance.
Sans préjudice des dispositions de l’article ST-34 ci-après, pour les questions qui relèvent de la compétence des Juri-

dictions Fédérales, les Membres s’interdisent tout recours aux tribunaux judiciaires ordinaires.

ST-29. Procédure devant les Juridictions Fédérales. Les principes fondamentaux du droit tels que notamment le respect

des droits de la défense et le principe du contradictoire sont applicables devant les Juridictions Fédérales.

L’administrateur responsable des Statuts et des affaires judiciaires, ou en cas d’empêchement, un autre administrateur,

est délégué aux séances des Juridictions Fédérales avec pour mission de faire état des infractions, de requérir les sanctions
appropriées, d'exposer l’avis du Conseil d’Administration ou de défendre les intérêts majeurs de la Fédération.

Les procédures devant les Juridictions Fédérales, les infractions et les peines applicables sont détaillées dans un Rè-

glement Administratif.

ST-30. Remise gracieuse de peines. Article abrogé par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 5 mai 2012.

181053

L

U X E M B O U R G

VI. Dispositions finales

ST-31. Exercice social. L'exercice social de la Fédération commence le premier juillet de chaque année et se termine

le trente juin de l’année suivante.

ST-32. Budget annuel et règlement des comptes. Le budget annuel se compose d'un budget des recettes et d'un budget

des dépenses.

Il comprend toutes les recettes brutes et toutes les dépenses brutes sans exception. La compensation des recettes et

des dépenses est interdite. Le budget se subdivise en sections regroupant les recettes et les dépenses selon les différents
organes de la Fédération. La numérotation des articles doit être continue.

ST-33. Hiérarchie des normes. Les présents Statuts sont complétés par des Règlements Administratifs et par des

Circulaires qui doivent en tout état de cause être conformes aux présents Statuts et aux réglementations obligatoires
pour la Fédération en raison de son affiliation à des organisations nationales et internationales.

ST-34. Commission luxembourgeoise d’arbitrage. La FLBB se soumet avec l’ensemble de ses Clubs, Licenciés et Mem-

bres à la Commission luxembourgeoise d'arbitrage pour le sport, créée par le C.O.S.L. Elle reconnaît à cet organisme le
droit de statuer dans le cadre de ses attributions, conformément à son règlement qui est annexé aux présents Statuts.

Le recours à la Commission n’est pas suspensif.

ST-35. Lutte contre le dopage. La Fédération, sans préjudice des obligations résultant de son affiliation à la Fédération

internationale régissant son sport, proscrit l’utilisation par les sportifs et l’administration aux sportifs de substances ou
de moyens de dopage.

En matière de lutte contre le dopage, la Fédération se soumet avec toutes ses Sociétés-Membres et tous ses Licenciés

à l’autorité de l’Agence Luxembourgeoise Antidopage. Elle reconnaît à cet organisme:

- le droit d'établir les règles et principes de la lutte antidopage et de fixer les modalités et procédures suivant lesquelles

cette lutte et plus particulièrement les contrôles antidopage sont menés, y compris les règles protectrices des droits des
licenciés;

- le droit de déterminer les sanctions qu’encourent ceux qui contreviennent aux règles dont question au tiret qui

précède;

- le droit de procéder aux contrôles antidopage parmi ses licenciés, notamment de fixer le programme des contrôles

et de désigner les licenciés à contrôler, ainsi que de choisir le ou les établissements effectuant les examens de laboratoire;

- le droit de diriger les poursuites devant le Conseil de Discipline contre le Dopage chargé de prononcer, s’il y a lieu,

les sanctions, pour autant que l’instance se déroule au Luxembourg, y compris le droit de faire appel contre un jugement
de première instance.

La Fédération cède au Conseil de Discipline contre le Dopage, institué à cet effet par le COSL, le pouvoir de connaître

des infractions aux règles de la lutte antidopage dont question à l’alinéa qui précède, sous réserve des attributions du
Tribunal Arbitral pour le Sport du Comité Olympique International pour les sportifs et manifestations internationales qui
relèvent de sa juridiction.

Toute disposition des Statuts contraire aux présentes dispositions est réputée non écrite.

ST-36. Dissolution. La dissolution de la Fédération ne peut être prononcée que selon les dispositions de la Loi du 21

avril 1928 sur les associations sans but lucratif. L'actif net reviendra dans ce cas à une oeuvre de bienfaisance active dans
le domaine du sport.

ST-37. Renvoi. Pour les cas non prévus aux présents Statuts, il est renvoyé aux dispositions de la Loi du 21 avril 1928

précitée.

Luxembourg, le 18 novembre 2014.

Référence de publication: 2014184161/353.
(140207420) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2014.

Junker Claude S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2342 Luxembourg, 7, rue Poincaré.

R.C.S. Luxembourg B 79.376.

Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Référence de publication: 2014178580/10.
(140204975) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2014.

181054

L

U X E M B O U R G

DC Harlow Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 10.000,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 191.245.

In the year two thousand and fourteen, on the twentieth day of October.
Before Us, Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

DC Harlow Investco S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated under

the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of ten thousand pounds sterling (GBP 10,000.-), with
its registered office at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, in the process of being registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés),

hereby represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, an employee of the notary, residing professionally

at 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

I. The said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
II. The appearing party declares that it is the sole shareholder (the Sole Shareholder) of DC Harlow Holdco S.à r.l., a

private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated under the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg, with a share capital of ten thousand pounds sterling (GBP 10,000.-), with its registered office at 6, rue Eugène
Ruppert, L-2453 Luxembourg, in the process of being registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
(Registre de Commerce et des Sociétés) (the Company), incorporated by a deed of Maître Francis Kesseler, prenamed,
of 30 September 2014, whose publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations is currently pending
(the Articles).

III. The appearing party, represented as above mentioned, having recognised to be fully informed of the resolutions to

be taken on the basis of the following agenda:

<i>Agenda:

1. To change the financial year of the Company which shall now start on the 1 

st

 of April of each year and end on the

31 

st

 March of each following year, and consequently to amend article 12.1 of the Articles so that it will henceforth read

as follows:

« Art. 12.1. The Company's financial year starts on the 1 

st

 of April and ends on the 31st of March of the following

year.»;

2. To increase the term of the first financial year to have it terminated on 31 March 2015; and
3. Miscellaneous,
has requested the undersigned notary to document the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder RESOLVES to change the financial year of the Company which shall now start on the 1 

st

 of

April of each year and end on the 31st March of each following year, and consequently to amend article 12.1 of the Articles
so that it will henceforth read as follows:

« Art. 12.1. Financial year. The Company's financial year starts on the 1 

st

 of April and ends on the 31 

st

 of March of

the following year.».

<i>Second resolution

The Sole Shareholder RESOLVES to increase the term of the first financial year to have it terminated on 31 March

2015.

<i>Declaration

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the date stated at the beginning of this

document.

The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person the present

deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of any differences
between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by its surname, first name, civil

status and residence, the said person signed together with Us, the notary, this original deed.

181055

L

U X E M B O U R G

Suit la version française

L'an deux mille quatorze, le vingtième jour du mois d'octobre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

DC Harlow Investco S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché

de Luxembourg, ayant son siège social au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
ayant un capital social de dix milles livres sterling (GBP 10.000) et dont l’enregistrement auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg est en cours,

ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée du notaire, résidant à Esch-sur-

Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.

I. Ladite procuration restera annexée au présent acte pour être soumise à l’enregistrement.
II. La partie comparante déclare qu'elle est l’associé unique (l’Associé Unique) de DC Harlow Holdco S.à r.l., une

société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège
social au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de dix milles
livres sterling (GBP 10.000) et dont l’enregistrement auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
est en cours (la Société), constituée par un acte de Maître Francis Kesseler, prénommé, en date du 30 septembre 2014,
et dont la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations est en cours (les Statuts).

III. La partie comparante, dûment représentée, ayant reconnu être entièrement informée des résolutions à prendre

sur base de l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Décider de modifier l’exercice social de la Société qui désormais commence le 1 

er

 avril de chaque année et se

termine le 31 mars de l’année suivante et en conséquence de modifier l’article 12.1 des Statuts qui aura désormais la
teneur suivante:

« Art. 12.1 Exercice social. L'exercice social de la Société commence 1 

er

 avril et se termine le 31 mars de l’année

suivante.»

2. Décider d'étendre la durée du premier exercice social pour le clôturer au 31 mars 2015; et
3. Divers,
a requis le notaire soussigné de documenter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé Unique DECIDE de modifier l’exercice social de la Société qui désormais commence le 1 

er

 avril de chaque

année et se termine le 31 mars de l’année suivante et en conséquence de modifier l’article 12.1 des Statuts qui aura
dorénavant la teneur suivante:

« Art. 12.1 Exercice social. L'exercice social de la Société commence 1 

er

 avril et se termine le 31 mars de l’année

suivante.»

<i>Seconde résolution

L'Associé Unique DECIDE d'augmenter la durée du premier exercice social pour le faire finir au 31 mars 2015.

<i>Déclaration

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, à la date en tête du présent document.
Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-

avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes comparants,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte fait et interprétation donnée au comparant à Esch-sur-Alzette, connu du notaire instrumentant

par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 24 octobre 2014. Relation: EAC/2014/14380. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2014179098/100.
(140205585) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2014.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

181056


Document Outline

Aconit Invest S.A.

Alliance Data Lux Holdings S.à r.l.

ASF II Euro Mountain

Athena Consulting S.A.

Athinea S.A. SPF

Atlantic Explorator Company S.A.

Aurore Invest Fund

Azur Clean S.A.

Barlux S.A.

Bevis Marks Holding S.à r.l.

DC Harlow Holdco S.à r.l.

D.R.C. S.A.

Elonis S.à r.l.

ExIP S.à r.l.

Fédération Luxembourgeoise de Basketball

Filotel S.A.

FR Prime Holdings III (Luxembourg) S.à r.l.

GCE Holdco S.à r.l.

GCE Luxco S.à r.l.

Global Pharm Holding S.à r.l.

Groupe Acticall

Halian S.à r.l.

Harbour LuxCo S.à r.l.

Junker Claude S.à r.l.

Kant Capital Fund S.C.A. SICAV-SIF

LSREF3 Dutch Investments S.à r.l.

Lucenda S.à r.l.

Sagas S.A.

Salon de Coiffure Millen Isabelle S.à .r.l.

Sogel

Stampalux S.A.

Sterren Investments S.A.

STG IBS Holding S.à r.l.

Stoneship S.à r.l.

Studor S.A.

Symbiose

Target Investments S.A.

Tarpan LuxCo S.à r.l.

Teak Luxembourg S.A.

Telewatch International S.A.

Telewatch International S.A.

Thermo Fisher Scientific Luxembourg Life Technologies UK Holding S.à r.l.

Thonex France S.A.

TIM w.e. Holding S.à r.l.

Tracer S.à r.l.

Translogistics S. A.

Treid SA

Trinova Select ESP S.à r.l.

UL S.à.r.l.

UPX International 2 S.à r.l.