This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 3676
3 décembre 2014
SOMMAIRE
A fleur de peau, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
176413
Auto Team s.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
176407
AXA Investplus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
176446
AXA Luxembourg Fund . . . . . . . . . . . . . . . .
176444
Blue Eagle Portfolios . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
176419
Carnegie Wealth Management Fund Sicav
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
176421
CIEI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
176416
C & I Latam S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
176404
Climmolux Holding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
176444
DHC Luxembourg V S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
176402
DRC2 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
176405
Eficar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
176404
Energie 5 Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
176445
Equipements, Fluides et Gaz-Technologies
Appliquées S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
176405
Erlo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
176443
EuroCore Property 3 S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
176410
Europalux Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
176409
Evong S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
176405
Fame International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
176448
Fincorp Participations S.A. . . . . . . . . . . . . . .
176413
Fondation Sociale Holding S.A. . . . . . . . . . .
176442
Hamada SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
176402
Immobilière Saint Marcel S.A. . . . . . . . . . .
176445
Immo Teb SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
176403
Inspiration & Information Sàrl . . . . . . . . . . .
176445
IRE Hotel II HoldCo 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
176435
JC. Partner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
176438
Kaiser Investments Holdings S.à r.l. . . . . . .
176403
KDC Investments Luxembourg Sàrl . . . . .
176431
KÖHL Aktiengesellschaft . . . . . . . . . . . . . . .
176446
LBLux SICAV-FIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
176406
Le Midofa S.C.I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
176439
Locomotive Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
176447
Marie Property S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
176406
Mendocino S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
176413
Mine Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
176447
MONTECARO S.A., société de gestion de
patrimoine familial, "SPF" . . . . . . . . . . . . .
176443
Motorola Solutions Holding S.à r.l. . . . . . .
176448
NRG 6 S.A. SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
176443
NRG 7 S.A. SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
176447
Opportunity Umbrella Fund . . . . . . . . . . . .
176421
PIM S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
176409
Primva S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
176404
Pub.K Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
176444
Recar-Int . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
176407
REIM EuroCore 1 S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
176410
Roof Garden S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
176419
Sheridan Solutions SICAV-FIS . . . . . . . . . .
176403
Swiss Alpha, SICAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
176404
Timberland, SICAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
176405
Ulrika S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
176446
Woodimmo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
176402
176401
L
U X E M B O U R G
DHC Luxembourg V S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 3.861.533,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 123.613.
<i>Extrait des résolutions écrites des associés de la Société du 31 octobre 2014i>
Il résulte des résolutions écrites du 31 octobre 2014 que:
- Monsieur Fabian Sires, employé privé, ayant son adresse professionnel au 46a, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxem-
bourg, a été nommé gérant avec effet au 1
er
novembre 2014 et pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signé à Luxembourg, le 5 novembre 2014.
<i>Pour la Société
i>Cédric Stébel
Référence de publication: 2014172775/16.
(140197900) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2014.
Hamada SA, Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 130.885.
Convening notice to the
ORDINARY SHAREHOLDER'S MEETING
to be held on <i> DECEMBER 23 i>
<i>rdi>
<i> , 2014 i> at 10.00 A.M. at the official seat of the company 11, avenue Emile Reuter,
L-2420 Luxembourg, to deliberate on the following agenda.
<i>Agenda:i>
1. Increase of the number of Company's Directors from 3 to 4 and appointment of Mr Alain BRETON as new Com-
pany's Director
2. Miscellaneous
Find enclosed a proxy to be returned duly signed to the official seat of the company may you have no opportunity to
attend the said meeting.
<i>THE BOARD OF DIRECTORS.i>
Référence de publication: 2014183939/17.
Woodimmo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 7A, rue des Glacis.
R.C.S. Luxembourg B 94.198.
Messieurs, Mesdames, les actionnaires, nous avons l'honneur de vous convoquer en
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
le <i>19 décembre 2014i> à dix heures, par devant Maître Gérard Lecuit, notaire au 31 Boulevard Prince Henri, L-1724
Luxembourg, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
•
Réduction du capital d'un montant de 341.100 euros pour le porter à 500.000 euros pour compenser des pertes
qui n'ont pu être absorbées par d'autres fonds propres,
•
Modifications corrélatives à la décision précédente de l'article 3 des statuts,
•
Mise en harmonie des statuts avec les modifications de la loi du 10 août 1915 ; à l'article 6 suppression de l'alinéa
10, requérant l'autorisation préalable de l'assemblée générale en cas de délégation par le Conseil d'Administration
de ses pouvoirs de gestion journalière,
•
Suppression à l'article 7 des statuts de la possibilité de nommer un actionnaire commissaire à la surveillance de la
société,
•
Questions diverses.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2014190793/21.
176402
L
U X E M B O U R G
Immo Teb SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 107.011.
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Qui se tiendra chez le Notaire Joëlle SCHWACHTGEN de résidence à Wiltz, en date du <i>19 décembre 2014i> à 12
heures, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Transfert du siège social et modification subséquente des statuts;
2. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2014191607/1004/14.
Kaiser Investments Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 189.896.
Conformément à la cession des parts sociales du 29 Octobre 2014, la société Urbanus Holdings Limited, avec adresse
au 6 étage, bâtiment NeXTeracom, MS - Ebene, Ile Maurice, a transféré 12,500 parts sociales détenues dans la Société,
à Honestas Ventures Limited, avec adresse au 6 étage, bâtiment NeXTeracom, MS - Ebene, Ile Maurice.
Le nouvel associé de la Société est Honestas Ventures Limited, et la cession des parts sociales, a été reportée sur le
registre des associés de la Société.
Luxembourg, le 5 Novembre 2014.
Pour extrait sincère et conforme
Référence de publication: 2014172991/15.
(140197627) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2014.
Sheridan Solutions SICAV-FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement
Spécialisé.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 158.943.
Shareholders are hereby kindly invited to attend a
GENERAL MEETING
of Shareholders of the Company (the "Meeting") which will be held on <i>December 22, 2014i> at 2 p.m. (Luxembourg
time) at the premises of the Company: 22, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with the
following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Information about the current situation of the Company;
2. Miscellaneous
Participation in the annual general meeting is limited to those shareholders who submit to the company a securities
account statement from a bank before December 20, 2014 which shows that the shares are blocked until the end of the
annual general meeting. Shareholders may appoint proxies to act on their behalf. Such appointments must be made in
writing.
Proxies and bank account statements have to be returned before December 20, 2014 by fax, e-mail or conventional
mail to the Company at fax number +352 26 89 71 91, by email at info@sheridan-consult.lu or by mail to the registered
office of the Company: 22, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
If you have any questions concerning this notice, please contact the Company at its registered office: 22, rue Goethe,
L-1637 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
<i>The Liquidatorsi>
Référence de publication: 2014188696/655/25.
176403
L
U X E M B O U R G
Primva S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3389 Peppange, 7, rue Jean-Jacques Knepper.
R.C.S. Luxembourg B 145.759.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014176423/9.
(140201733) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2014.
C & I Latam S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 164.070.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 novembre 2014.
Référence de publication: 2014176751/10.
(140202989) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2014.
Eficar, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 175.973.
Les comptes pour la période du 8 mars 2013 au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 novembre 2014.
Référence de publication: 2014177520/11.
(140203531) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2014.
Swiss Alpha, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 3, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 148.588.
Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit laden wir Sie zu einer
AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
des Swiss Alpha, SICAV am <i>19. Dezember 2014i> um 10:00 Uhr, in den Geschäftsräumen der Banque LBLux am Sitz der
Gesellschaft, 3, rue Jean Monnet, L- 2180 Luxemburg ein. Als Tagesordnungspunkt wurde vorgeschlagen:
<i>Tagesordnung:i>
• 1. Verlegung des Geschäftssitzes
vorher
nachher
Ab dem 22.12.2014
3, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg
6, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Muns-
bach
2. Sonstiges
Zur Teilnahme an der außerordentlichen Generalversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen
Aktionäre berechtigt, die bis spätestens 17. Dezember 2014 die Depotbestätigung eines Kreditinstituts bei der Gesell-
schaft einreichen aus der hervorgeht, dass die Aktien bis zur Beendigung der Generalversammlung gesperrt gehalten
werden. Aktionäre können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevollmächtigt ist.
Es besteht kein Quorum für die außerordentliche Generalversammlung. Die Beschlüsse werden durch einfache Mehr-
heit der anwesenden oder vertretenden Aktionäre gefasst.
<i>Der Verwaltungsrat.i>
Référence de publication: 2014190791/10183/24.
176404
L
U X E M B O U R G
Evong S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.
R.C.S. Luxembourg B 157.875.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014177530/9.
(140203411) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2014.
DRC2 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 2, Am Hock.
R.C.S. Luxembourg B 188.526.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 novembre 2014.
Référence de publication: 2014177514/10.
(140203571) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2014.
Equipements, Fluides et Gaz-Technologies Appliquées S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9085 Ettelbruck, 9, ZAC Hall.
R.C.S. Luxembourg B 176.950.
Les comptes annuels au 31-12-2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la gérance
i>Signature
Référence de publication: 2014177527/11.
(140204185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2014.
Timberland, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 3, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 161.772.
Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit laden wir Sie zu einer
AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
des Timberland, SICAV am <i>19. Dezember 2014i> um 9:30 Uhr, in den Geschäftsräumen der Banque LBLux am Sitz der
Gesellschaft, 3, rue Jean Monnet, L- 2180 Luxemburg ein. Als Tagesordnungspunkt wurde vorgeschlagen:
<i>Tagesordnung:i>
• 1. Verlegung des Geschäftssitzes
vorher
nachher
Ab dem 22.12.2014
3, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg
6, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Muns-
bach
2. Sonstiges
Zur Teilnahme an der außerordentlichen Generalversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen
Aktionäre berechtigt, die bis spätestens 17. Dezember 2014 die Depotbestätigung eines Kreditinstituts bei der Gesell-
schaft einreichen aus der hervorgeht, dass die Aktien bis zur Beendigung der Generalversammlung gesperrt gehalten
werden. Aktionäre können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevollmächtigt ist.
Es besteht kein Quorum für die außerordentliche Generalversammlung. Die Beschlüsse werden durch einfache Mehr-
heit der anwesenden oder vertretenden Aktionäre gefasst.
<i>Der Verwaltungsrat.i>
Référence de publication: 2014190792/10183/24.
176405
L
U X E M B O U R G
Marie Property S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 148.844.
Par lettre recommandée adressée le 13 novembre 2014 à la société MARIE PROPERTY S.A. (en liquidation volontaire),
société anonyme avec siège social à L-1449 Luxembourg, rue de l'Eau n°18, la société FIDUCENTER S.A. a mis fin de
plein droit au contrat de domiciliation avec ladite société MARIE PROPERTY S.A. (en liquidation volontaire) avec effet
immédiat.
Partant, le siège social de ladite société MARIE PROPERTY S.A. (en liquidation volontaire) est dénoncé à la même
date.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCENTER S.A.
<i>Le domiciliatairei>
Référence de publication: 2014177030/15.
(140202463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2014.
LBLux SICAV-FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 3, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 132.782.
Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit laden wir Sie zu einer
AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
des LBLux SICAV-FIS am <i>19. Dezember 2014i> um 9.00 Uhr, in den Geschäftsräumen der Banque LBLux am Sitz der
Gesellschaft, 3, rue Jean Monnet, L- 2180 Luxemburg ein. Als Tagesordnungspunkt wurde vorgeschlagen:
<i>Tagesordnung:i>
• 1. Satzungsänderung
vorher
nachher
Art. 21. Absatz 2
Kosten
Die Depotbank berechnet Depotbank-gebüh-
ren. Diese Depotbankgebühren beinhalten in
der Regel alle fremden Verwahrungs- und Ver-
waltungsgebühren, die von anderen Korrespon-
denzbanken und/ oder Clearingstellen (z.B.
Clearstream oder Euroclear) für die Verwah-
rung der Vermögenswerte der Gesellschaft in
Rechnung gestellt werden.
Des Weiteren erhält die Depotbank aus dem
Vermögen eines jeden Teilfonds eine bankenüb-
liche Umsatzprovision auf jede Wertpapiert-
ransaktion an einer öffentlichen Börse oder im
Freiverkehr;
Die Depotbank berechnet eine jährliche Depot-
bankgebühr von bis zu 0,7%, zahlbar monatlich,
berechnet auf den letzten Nettoinventarwert ei-
nes jeden Teilfonds am Ende eines jeden Monats.
Fremde Verwahrungs- und Verwaltungsgebüh-
ren, die von anderen Korrespondenzbanken
und/oder Clearing-stellen (z.B. Clearstream
oder Euroclear) für die Verwahrung der Ver-
mögenswerte des Fonds anfallen, werden dem
Fondvermögen gesondert in Rechnung gestellt.
2. Verlegung des Geschäftssitzes
vorher
nachher
Ab dem 22.12.2014
3, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg
6, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Muns-
bach
3. Sonstiges
Zur Teilnahme an der außerordentlichen Generalversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen
Aktionäre berechtigt, die bis spätestens 17. Dezember 2014 die Depotbestätigung eines Kreditinstituts bei der Gesell-
schaft einreichen aus der hervorgeht, dass die Aktien bis zur Beendigung der Generalversammlung gesperrt gehalten
werden. Aktionäre können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevollmächtigt ist.
Es besteht kein Quorum für die außerordentliche Generalversammlung. Die Beschlüsse werden durch einfache Mehr-
heit der anwesenden oder vertretenden Aktionäre gefasst.
<i>Der Verwaltungsrat.i>
Référence de publication: 2014190790/10183/49.
176406
L
U X E M B O U R G
Auto Team s.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9155 Grosbous, 20, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 97.367.
Recar-Int, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9155 Grosbous, 20, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 136.182.
L’an deux mille quatorze, le vingt-six novembre.
Par devant Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
Ont comparu:
a) Monsieur Giovanni ANTONACCI, commerçant, demeurant à L-9371 Gilsdorf, 24, rue des Prés,
b) Monsieur Manuel DRAGO PANTAS DUARTE, gérant technique, demeurant 1, um Weiher à L-9805 Hosingen,
gérants de la société à responsabilité limitée AUTO-TEAM S.à r.l. avec siège social à L-9155 Grosbous, 20, route
d’Arlon,
constituée suivant acte reçu par le notaire Marc Cravatte, alors de residence à Ettelbruck en date du 20 janvier 1993,
publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, page 8027 de l’année 1993,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro d'immatriculation B 97.367,
II. Monsieur Giovanni ANTONACCI, préqualifié,
gérant unique de la société à responsabilité limitée «RECAR-INT» (matricule 2008 2402 986), avec siège social à L-9155
Grosbous, 20, route d’Arlon,
constituée sous le nom de «R.C.I. S.à r.l.»suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 17 janvier 2008,
publié au Mémorial C, numéro 621 du 13 mars 2008,
et dont le nom a été changé en «RECAR-INT» suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 12 février
2008, publié dans le prédit Mémorial C, numéro 621 du 12 mars 2008,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro d'immatriculation B 136.182,
Lesquels ont requis le notaire instrumentant d'acter en la forme authentique le projet de fusion qui suit:
<i>Données et objectifs de la fusion projetéei>
La société anonyme AUTO TEAM S. à r.l. déclare vouloir absorber la société à responsabilité limitée RECAR-INT.
En effet une restructuration est envisagée au niveau du groupe auquel ces deux sociétés appartiennent pour simplifier
la structure du groupe et pour épargner des frais d’administration, ce d’autant plus que les deux sociétés n’ont qu’un seul
porteur de parts. Les gérants des deux sociétés sont donc d’avis que la fusion devrait être réalisée pour ces raisons
financières et économiques.
DISPOSITIONS DU PROJET DE FUSION
<i>Description des sociétés à fusionneri>
1. Société absorbante.
La société à responsabilité limitée AUTO-TEAM S.à r.l. avec siège social à L-9155 Grosbous, 20, route d’Arlon,
constituée suivant acte reçu par le notaire Marc Cravatte, alors de résidence à Ettelbruck en date du 20 janvier 1993,
publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, page 8027 de l’année 1993,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro d'immatriculation B 97.367,
ci-après désignée la "Société Absorbante",
Son capital social s'élève à 12.500 Euros. Le capital social est divisé en 500 parts sociales d’une valeur nominale de 25
Euros chacune, toutes intégralement souscrites et libérées.
2. Société absorbée.
La société à responsabilité limitée «RECAR-INT» (matricule 2008 2402 986), avec siège social à L-9155 Grosbous, 20,
route d’Arlon,
constituée sous le nom de «R.C.I. S.à r.l.» suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 17 janvier 2008,
publié au Mémorial C, numéro 621 du 12 mars 2008,
et dont le nom a été changé en «RECAR-INT» suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 12 février
2008, publié dans le prédit Mémorial C, numéro 621 du 13 mars 2008,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro d'immatriculation B 136.182,
Son capital social s'élève à douze mille quatre cents euros (12.400,-€) divisé en cent (100) parts sociales de cent vingt-
quatre euros (124,- €) chacune, entièrement souscrit et libéré.
176407
L
U X E M B O U R G
<i>Modalités de la fusioni>
La fusion sera réalisée par voie d'absorption de la société à responsabilité RECAR-INT par la société à responsabilité
limitée AUTO TEAM SARL.
<i>Parts sociales nouvelles - Rapport d'échangei>
Le projet de fusion est basé sur les situations comptables intermédiaires respectives de la Société Absorbée et de la
Société Absorbante établis à la date du 31 août 2014.
A cette date la valeur comptable de la société RECAR-INT était de 6.130,47 €.
A cette date la valeur comptable de la société AUTO-TEAM SARL était de -395.449,20 €.
Comme les deux sociétés n’ont qu’un seul et le même porteur de parts il n’y aura pas d’émission de nouvelles parts
sociales mais augmentation de la valeur des parts sociales existantes de la société absorbante.
Lors de la fusion l’augmentation de capital de la société AUTOTEAM SARL sera de 12.400.- € pour porter le capital
à 24.900.- € et le capital sera alors représenté par 500 parts sociales.
<i>Dates de prise d'effet sur le plan comptable et juridiquei>
La date à partir de laquelle les opérations de la Société Absorbée sont conventionnellement considérées du point de
vue comptable et fiscal comme accomplies pour le compte de la Société Absorbante est fixée au 30 novembre 2014, et
tous bénéfices ou pertes réalisées par la Société Absorbée après cette date sont censés réalisés pour le compte de la
Société Absorbante.
La fusion sera réalisée à la date où seront intervenues les décisions concordantes prises au sein des sociétés en cause
c'est-à-dire à la date de la dernière assemblée générale des sociétés fusionnantes approuvant le projet et la fusion et sera
opposable aux tiers après la publication de ces assemblées au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Conformément à l’article 271 de la loi modifiée du 10 août 1915 la fusion définitive sera réalisée par acte notarié du
notaire instrumentaire et sera publié au Mémorial C. Recueil spécial des Sociétés et Associations.
La fusion interviendra sans conséquences fiscales conformément à l’article 170, paragraphe 2 L.I.R.
<i>Respect des droits particuliersi>
Au moment de la fusion, la Société Absorbée ne comptera aucune parts sociale ayant des droits spéciaux, aucun
emprunt obligataire, aucune part de fondateurs ou titres quelconques autres que des parts sociales. Il n'y a dès lors pas
à indiquer les mesures proposées à l’égard d'associés ayant des droits spéciaux ou de porteurs de titres pour assurer le
respect de leurs droits.
<i>Attribution d'avantages particuliersi>
Il n'est accordé, par l’effet de la fusion, aucun avantage particulier ni aux gérants, ni aux experts, ni aux commissaires
des deux sociétés qui fusionnent.
<i>Conséquences de la fusioni>
La fusion par absorption entraînera de plein droit toutes les conséquences prévues par l’article 274 de la loi modifiée
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Ainsi, par l’effet de la fusion, la Société Absorbée sera dissoute, toutes
les parts représentant son capital social seront annulées et tous ses actifs et passifs seront universellement transmis de
plein droit à la Société Absorbante.
Le mandat du gérant prend fin à la date d'effet de la fusion. La décharge sera proposée à l’assemblée générale d'ap-
probation de la fusion.
<i>Informationi>
Tous les porteurs de parts de la Société Absorbée et de la Société Absorbante ont le droit, un mois au moins avant
la date de la réunion de l’Assemblée Générale Extraordinaire appelée à se prononcer sur le projet de fusion et sous
réserve de renonciation à ce droit, de prendre connaissance au siège social de la société dont ils sont porteurs de parts,
du projet de fusion, des comptes annuels, y compris ceux au 31 août 2014 (pour la Société Absorbante) et au 31 août
2014 (pour la Société Absorbée), même non encore approuvés ni déposés, ainsi que des rapports de gestion et tous
autres documents, tels que déterminés à l’article 267 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Les documents sociaux de la Société Absorbée seront conservés pendant le délai légal au siège de la Société Absor-
bante.
La Société Absorbante procédera à toutes les formalités nécessaires ou utiles pour donner effet à la fusion et à la
transmission universelle de tous les avoirs et obligations par la Société Absorbée à la Société Absorbante.
Lors de la réalisation définitive de la fusion, la société absorbée remettra à la société absorbante les originaux de tous
ses actes constitutifs et modificatifs ainsi que les livres de comptabilité et autres documents comptables, les titres de
propriété ou actes justificatifs de propriété de tous les éléments d'actif, les justificatifs des opérations réalisées, les valeurs
mobilières ainsi que tous contrats, archives, pièces et autres documents quelconques relatifs aux éléments et droits
apportés.
176408
L
U X E M B O U R G
<i>Déclaration des comparantsi>
Le(s) associé(s) déclare(nt), en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu’elle a été modifiée par la suite, être
le(s) bénéficiaire(s) réel(s) de la société faisant l’objet des présentes et certifie(nt) que les fonds/biens/ droits servant à la
libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités constituant
une infraction visée aux articles 506-1 du Code pénal et 8-1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l’article
135-5 du Code Pénal (financement du terrorisme).
IMMEUBLE
Aucune des sociétés ne possède d’immeuble.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare attester la légalité du présent projet de fusion, conformément aux dispositions de la loi
sur les sociétés commerciales, tel que modifiée.
Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Giovanni ANTONACCI, Manuel DRAGO PANTAS DUARTE, Pierre PROBST.
Enregistré à Diekirch, Le 26 novembre 2014. Relation: DIE/2014/15201. Reçu douze euros 12,00.-€.
<i>Le Receveuri>
(signé): Tholl.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande et aux fins de publication au Mémorial.
Ettelbruck, le 28 novembre 2014.
Référence de publication: 2014189987/128.
(140211707) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2014.
Europalux Holding S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-8010 Strassen, 204, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 33.156.
L'assemblée générale des actionnaires tenue le 11 novembre 2014 a décidé de renouveler le mandat du commissaire
aux comptes jusqu'à la tenue de l'assemblée générale annuelle à tenir en 2016. Il s'agit de la société EUROFISC S.A., 69,
rue Pierre Krier, L-1880 Luxembourg.
Référence de publication: 2014176085/10.
(140202165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2014.
PIM S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9366 Ermsdorf, 10, rue de Savelborn.
R.C.S. Luxembourg B 141.079.
En date du 12.11.2014, les associés ont pris les décisions suivantes:
1. Démission du gérant administratif
L'assemblée décide à l'unanimité d'accepter la démission de son mandat de:
- Monsieur Miguel Pedro LOPES PIMENTA, gérant de société, né à Ettelbruck le 29 août 1975 demeurant à L-9366
Ermsdorf, 10 rue Savelborn.
2. Démission du gérant technique
L'assemblée décide à l'unanimité d'accepter la démission de son mandat de:
- Monsieur Richard Emile CHOLE, gérant de société, né à Homecourt le 18 mars 1946 demeurant à L-9283 Diekirch
53, Promenade de la Sûre
3. Nomination d'un nouveau gérant unique:
L'assemblée décide à l'unanimité de nommer au poste de gérant unique:
- Monsieur Miguel Pedro LOPES PIMENTA, gérant de société, né à Ettelbruck le 29 août 1975 demeurant à L-9366
Ermsdorf, 10 rue Savelborn.
<i>Pour l'Administration
i>Signature
Référence de publication: 2014176416/22.
(140201523) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2014.
176409
L
U X E M B O U R G
REIM EuroCore 1 S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 118.089.
EuroCore Property 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 134.875.
<i>Rectificatif du dépôt L140209601, déposé le 26/11/14.i>
In the year two thousand fourteen, on the fourteenth of November.
Before the undersigned, Maître Henri HELLINCKX, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
THERE APPEARED
1) REIM EuroCore 1 S.C.A., a “Société en commandite par actions” incorporated and existing under the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 44, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg, registered with Luxembourg trade and companies’ register under number B 118.089, here represented
by Elena Toshkova, professionally residing in Luxembourg, acting in her capacity as representative of the general partner
of REIM EUROCORE 1 S.C.A., pursuant to a circular resolution dated November 11
th
, 2014 (“REIM EUROCORE 1
Circular Resolution”).
2) EuroCore Property 3 S.à r.l., a “société à responsabilité limitée” incorporated and existing under the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 44, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg, registered with Luxembourg trade and companies’ register under number B 134.875 here represented
by Elena Toshkova, professionally residing in Luxembourg, acting in her capacity as representative of the sole manager of
EuroCore Property 3 S.à r.l., pursuant to a circular resolution dated November 11
th
, 2014 (“EuroCore Property 3
Circular Resolution”).
REIM EuroCore 1 Circular Resolution and EuroCore Property 3 Circular Resolution are hereinafter collectively re-
ferred to as the “Circular Resolutions”.
The Circular Resolutions, initialled ne variatur by the proxyholder of the appearing parties and the notary, will remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have required the undersigned notary to record the
following:
MERGER PROJECT
1) Merging parties
- REIM EuroCore 1 S.C.A., a “Société en commandite par actions” incorporated and existing under the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 44, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg, registered with Luxembourg trade and companies’ register under number B 118.089, as absorbing com-
pany (hereinafter referred to as “Absorbing Company”),
- EuroCore Property 3 S.à r.l., a “société à responsabilité limitée” incorporated and existing under the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 44, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg, registered with Luxembourg trade and companies’ register under number B 134.875, as absorbed com-
pany (hereinafter referred to as “Absorbed Company”),
2) The Absorbing Company holds 8,800 shares of the Absorbed Company, representing the entire share capital (100%)
and all of the voting rights of the Absorbed Company.
3) The Absorbing Company and the Absorbed Company are referred hereto as the “Merging Companies”.
The Absorbing Company proposes to absorb the Absorbed Company by way of transfer of all assets and liabilities of
the Absorbed Company to the Absorbing Company at book value, pursuant to provisions of articles 278 to 280 of the
law of 10 August 1915 on commercial companies as amended from time to time (the “Law”) (the “Merger”).
4) The Merger is based on the interim accounts as at 30 September 2014 of the Absorbing Company at book value
and on the interim accounts as at 30 September 2014 at book value of the Absorbed Company.
5) As from 1
st
January 2015, all operations and transactions of the Absorbed Company are considered for accounting
purposes as being carried out on behalf of the Absorbing Company.
6) As of the effective date (as defined below), all rights and obligations of the Absorbed Company vis-a-vis third parties
shall be taken over by the Absorbing Company. The Absorbing Company will in particular take over all debts and all
payment obligations of the Absorbed Company. The rights and claims comprised in the assets of the Absorbed Company
shall be transferred to the Absorbing Company with all securities, either in rem or personal, attached thereto.
7) The Absorbing Company shall from the effective date (as defined below) carry out all agreements and obligations
of whatever kind of the Absorbed Company such as these agreements and obligations exist on the effective date (as
176410
L
U X E M B O U R G
defined below) and in particular carry out all agreements existing, if any, with the creditors of the Absorbed Company
and shall be subrogated to all rights and obligations from such agreements.
8) No special rights or advantages have been granted to the general partner or the board of managers of the Merging
Companies.
9) No particular right is granted to the shareholders by the Absorbing Company.
10) The Shareholders of the Absorbing Company have, within one month from the publication of this merger project
in the Mémorial, access at the registered office of the Absorbing Company to all documents listed in article 267 paragraph
(1) a), b) and c) of the Law and may obtain copies thereof, free of charge.
11) The partners of the Absorbing Company holding at least 5% of the subscribed share capital of the Absorbing
Company may, within the time period set out in paragraph 10) above, request the convening of a general meeting of
partners of the Absorbing Company to decide whether to approve the proposed merger.
12) Full and total discharge is granted to the managers of the Absorbed Company for the performance of their man-
dates.
13) Subject to the rights of the shareholders of the Absorbing Company set out in paragraph 10) above, the dissolution
of the Absorbed Company shall become effective and final one month after the publication of this merger project in the
Mémorial (the “Effective Date”) and will lead simultaneously to the effects set out in article 274 of the law.
14) As the Absorbing Company holds one hundred percent (100%) of the Absorbed Company and meets the requi-
rements provided by article 279 of the Law, no approval by an extraordinary general meeting of the Shareholder of the
Absorbed Company is required.
15) The Absorbing Company shall itself carry out all formalities, including such announcements as prescribed by law,
which are necessary or useful to carry into effect the Merger and the transfer and assignment of the assets and liabilities
of the Absorbed Company to the Absorbing Company. Insofar as required by law or deemed necessary or useful, ap-
propriate transfer instruments shall be executed by the Merging Companies to effect the transfer of the assets and liabilities
transferred by the Absorbed Company to the Absorbing Company.
16) The books and records of the Absorbed Company will be held at 44, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Grand-Duchy of Luxembourg for the period legally prescribed.
17) As a result of the Merger, the Absorbed Company shall cease to exist and all its issued shares shall be cancelled.
<i>Declarationi>
The undersigned notary public hereby certifies the existence and legality of the common draft terms of merger pursuant
to the Law.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above ap-
pearing parties, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same
appearing parties and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name,
civil status and residence, the said proxyholder signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède
L’an deux mille quatorze, le quatorze novembre,
Par-devant, Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
ONT COMPARU
1) REIM EuroCore 1 S.C.A., une «société en commandite par actions» constituée et existante selon les lois du Grand-
Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 44, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 118.089,
ici représentée par Elena Toshkova, résidant professionnellement au Luxembourg, agissant en qualité de mandataire
au nom et pour compte de l’associé-gérant commandité de REIM EuroCore 1 S.C.A., en vertu d’un pouvoir qui lui a été
conféré par l’Associé-Gérant Commandité de REIM EuroCore 1 le 11 Novembre 2014 à Luxembourg (la “Résolution
Circulaire de REIM EuroCore 1”); et
2) EuroCore Property 3 S.à r.l., une «société à responsabilité limitée» constituée et existante selon les lois du Grand-
Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 44, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 134.875
ici représentée par Elena Toshkova, résidant professionnellement au Luxembourg, agissant en qualité de mandataire
au nom et pour compte du gérant unique d’ EuroCore Property 3 S.à r.l., en vertu d’un pouvoir qui lui a été conféré par
le Conseil de gérance d’EuroCore Property 3 le 11 Novembre 2014 à Luxembourg (la “Résolution Circulaire d’EuroCore
Property 3”) La Résolution Circulaire de REIM EuroCore 1 S.C.A. et la Résolution Circulaire d’EuroCore Property 3
sont collectivement ci-après dénommés les “Résolutions Circulaires”.
176411
L
U X E M B O U R G
Les dites Résolutions Circulaires paraphées ne varietur par le mandataire des comparants et par le notaire soussigné,
resteront annexées au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
PROJET DE FUSION
1) Parties à la fusion:
- REIM EuroCore 1 S.C.A., une «société en commandite par actions» constituée et existante selon les lois du Grand-
Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 44, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 118.089, en tant
que société absorbante (la”Société Absorbante”); et
- EuroCore Property 3 S.à r.l., une «société à responsabilité limitée» constituée et existante selon les lois du Grand-
Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 44, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 134.875, en tant
que société absorbée (la “Société Absorbée”).
La Société Absorbante et la Société Absorbée sont collectivement dénommées les “Sociétés Fusionnantes”.
2) La Société Absorbante détient 8.800 parts sociales dans la Société Absorbée, représentant l’intégralité du capital
social et tous les droits de vote dans la Société Absorbée.
3) La Société Absorbante propose d'absorber la Société Absorbée par voie de transfert de tous les actifs et passifs de
la Société Absorbée à la Société Absorbante à la valeur nette comptable, suivant les dispositions des articles 278 à 280
de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la”Loi”) (la “Fusion”).
4) La Fusion est basée sur les comptes intérimaires au 30 septembre 2014 de la Société Absorbante et sur les comptes
intérimaires au 30 septembre 2014 de la Société Fusionnée à la valeur nette comptable.
5) A partir du 1
er
Janvier 2015, toutes les opérations et transactions de la Société Absorbée sont considérées du
point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la Société Absorbante.
6) A partir de la date de réalisation (telle que définie ci-dessous), tous les droits et obligations de la Société Absorbée
vis-à-vis des tiers seront pris en charge par la Société Absorbante. La Société Absorbante assumera en particulier toutes
les dettes et toutes les obligations de paiement de la Société Absorbée. Les droits et obligations de la Société Absorbée
seront transférés à la Société Absorbante avec l’intégralité des sûretés, soit in rem soit personnelles, y attachées.
7) La Société Absorbante exécutera à partir de la date de réalisation (telle que définie ci-dessous) tous les contrats et
obligations, de quelle que nature qu’ils soient, de la Société Absorbée tels que ces contrats et obligations existent à la
date de réalisation (telle que définie ci-dessous) et exécutera en particulier tous les contrats existant avec les créanciers
de la Société Absorbée et sera subrogée à tous les droits et obligations provenant de ces contrats.
8) Aucun droit ou avantage particulier n’a été attribué aux gérants des Sociétés Fusionnantes.
9) Aucun droit particulier n’est accordé aux associés par la Société Absorbante.
10) Les actionnaires de la Société Absorbante ont le droit, pendant un mois à compter de la publication de ce projet
de fusion au Mémorial, de prendre connaissance au siège social de la Société Absorbante de tous les documents énumérés
à l’article 267, alinéa (1) a), b) et c) de la Loi et peuvent en obtenir copie intégrale, sans frais.
11) Les associés de la Société Absorbante détenant au moins 5% du capital social souscrit de la Société Absorbante
ont le droit, pendant le délai indiqué sous le point 10) ci-dessus, de requérir la convocation d’une assemblée générale des
associés de la Société Absorbante appelée à se prononcer sur l’approbation de la fusion.
12) Décharge pleine et entière est accordée aux gérants de la Société Absorbée pour l’exercice de leur mandat.
13) Sous réserve des droits des actionnaires de la Société Absorbante tels que décrits sous le point 10) ci-dessous, la
dissolution de la Société Absorbée deviendra effective et définitive un mois après la publication de ce projet de fusion
dans le Mémorial (la “Date Effective”) et conduira simultanément aux effets tels que prévus par l’article 274 de la Loi.
14) La Société Absorbante détenant cent pour-cent (100%) des parts sociales émises de la Société Absorbée et les
conditions de l’article 279 de la Loi étant remplies, une approbation de la Fusion par l’assemblée générale extraordinaire
des associés de la Société Absorbée n’est pas requise.
15) La Société Absorbante devra elle-même accomplir toutes les formalités, y compris les publications telles que
prévues par la loi, qui sont nécessaires ou utiles à l’entrée en vigueur de la fusion et au transfert et cession des actifs et
passifs de la Société Absorbée à la Société Absorbante. Dans la mesure où la loi le prévoit, ou lorsque jugé nécessaire
ou utile, des actes de transfert appropriés seront exécutés par les Sociétés Fusionnantes afin de réaliser la transmission
des actifs et passifs de la Société Absorbée à la Société Absorbante.
16) Les documents sociaux de la Société Absorbée seront conservés au 44, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Grand-Duché of Luxembourg pendant la période prescrite par la loi.
17) Par effet de la fusion, la Société Absorbée cessera d’exister de plein droit et ses parts sociales émises seront
annulées.
176412
L
U X E M B O U R G
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare attester de l’existence et de la légalité du projet de fusion conformément à la Loi.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par la présente que sur demande des comparants, le
présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de
divergence entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg même date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, connu du notaire soussigné par nom,
prénom usuel, état de demeure, le mandataire des comparants a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: E. TOSHKOVA et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 17 novembre 2014. Relation: LAC/2014/54002. Reçu douze euros (12.- EUR).
<i>Le Receveuri>
(signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 25 novembre 2014.
Référence de publication: 2014190605/181.
(140210815) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2014.
A fleur de peau, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1741 Luxembourg, 83, rue de Hollerich.
R.C.S. Luxembourg B 124.983.
Les comptes annuels au 31-12-2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la gérance
i>Signature
Référence de publication: 2014177297/11.
(140203574) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2014.
Fincorp Participations S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 44.757.
Mendocino S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 52.471.
L'an deux mille quatorze, le quatorze novembre.
Par devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1. Monsieur Michaël ZIANVENI, juriste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg, agissant
en tant que mandataire du conseil d'administration de la société anonyme FINCORP PARTICIPATIONS S.A., (ci-après
la "société absorbante"), établie et ayant son siège social au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg, inscrite auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 44.757, constituée par acte de Maître Joseph
ELVINGER, alors notaire de résidence à Dudelange, en date du 4 août 1993, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 494 du 20 octobre 1993. Les statuts furent modifiés à plusieurs reprises suivant décision de
l’assemblée générale; la dernière fois, par acte reçu du notaire instrumentaire, de résidence à Luxembourg, en date du 9
décembre 2011 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 172 du 20 janvier 2012.
Le mandataire agit en vertu d'un pouvoir conféré par décision du conseil d'administration prise, sur base de l’article 6
des statuts de la société FINCORP PARTICIPATIONS S.A., par voie circulaire avec date d’effet le 5 novembre 2014, dont
une copie certifiée conforme restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
2. Monsieur Michaël ZIANVENI, prénommé, agissant en tant que mandataire du conseil d'administration de la société
anonyme MENDOCINO S.A., (ci-après la "société absorbée"), établie et ayant son siège social au 18, rue de l’Eau, L-1449
Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 52.471 con-
stituée par acte de Maître Georges d’HUART, alors notaire de résidence à Petange, en date du 28 septembre 1995, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 630 du 11 décembre 1995. Les statuts furent modifiés à
plusieurs reprises suivant décision de l’assemblée générale; la dernière fois, par acte reçu de Maître Joseph ELVINGER,
176413
L
U X E M B O U R G
notaire de résidence à Luxembourg en date du 18 avril 2006 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 1455 du 28 juillet 2006.
La mandataire agit en vertu d'un pouvoir conféré par décision du conseil d'administration prise, sur base de l’article 6
des statuts de la société MENDOCINO S.A., par voie de conférence téléphonique avec date d’effet du 5 novembre 2014,
dont une copie certifiée conforme restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l’enre-
gistrement.
Lesquelles comparantes ont déclaré et requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
Les conseils d'administration de la société absorbante et de la société absorbée ont approuvé le projet de fusion entre
la société FINCORP PARTICIPATIONS S.A. et la société MENDOCINO S.A. La société absorbante étant titulaire de
100 % des actions de la société absorbée, les sociétés FINCORP PARTICIPATIONS S.A. et MENDOCINO S.A. sont
dispensées de la tenue d'une assemblée générale, conformément aux articles 278 et 279 de la loi sur les sociétés com-
merciales, étant entendu qu'un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante disposant d'au moins 5% (cinq pour
cent) des actions du capital souscrit ont le droit de requérir, un mois au moins avant que l’opération ne prenne effet
entre parties, la convocation d'une assemblée générale de la société absorbante appelée à se prononcer sur l’approbation
de la fusion. Cette assemblée doit être convoquée de façon à être tenue dans le mois de la réquisition.
Conformément à l’article 271 (1) de la loi sur les sociétés commerciales, le projet de fusion est établi par les présentes
en la forme notariée.
Les termes du projet de fusion sont les suivantes:
1. La société FINCORP PARTICIPATIONS S.A., société anonyme, constituée en date du 4 août 1993, avec siège social
au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 44.757, au capital social de neuf cent dix-neuf mille sept cent cinq euros et soixante-neuf cents (EUR
919.705,69) représenté par mille cent cinquante (1.150) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées,
détient l’intégralité (100 %) des actions représentant la totalité du capital social (soit 1.250 actions) donnant droit de vote
de la société MENDOCINO S.A., société anonyme constituée en date du 28 septembre 1995, avec siège social au 18,
rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 52.471 au capital social de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (EUR 30.986,69)
représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.
Aucun titre donnant droit de vote n’a à ce jour été émis par les sociétés fusionnantes.
2. La société anonyme FINCORP PARTICIPATIONS S.A. (encore appelée la société absorbante) entend fusionner,
conformément aux dispositions des articles 278 et 279 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et les
textes subséquents et dans le cadre de la directive européenne réglementant les opérations de fusion, avec la société
anonyme MENDOCINO S.A. (encore appelée la société absorbée) par absorption de cette dernière.
3. La date à partir laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable comme
accomplies pour le compte de la société absorbante est fixée au 1
er
janvier 2014.
4. Aucun avantage particulier n’est attribué aux administrateurs, commissaires ou réviseurs des sociétés qui fusionnent.
5. La fusion prendra effet entre parties un mois après la publication du projet de fusion au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi sur les sociétés commerciales.
6. Les actionnaires de la société absorbante ont le droit pendant un mois à compter de la publication au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations du projet de fusion, de prendre connaissance, au siège, des documents indiqués à
l’article 267 (1) a), b) et c) de la loi sur les sociétés commerciales dont ils peuvent obtenir une copie intégrale sans frais
et sur simple demande.
7. Un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante, disposant d’au moins 5 % (cinq pour cent) des parts du capital
souscrit, ont le droit de requérir, pendant le même délai, la convocation d’une assemblée appelée à se prononcer sur
l’approbation de la fusion.
8. A défaut de convocation d’une assemblée ou du rejet du projet de fusion par celle-ci, la fusion deviendra définitive
comme indiqué ci avant au point 5) et entraînera de plein droit les effets prévus à l’article 274 de la loi sur les sociétés
commerciales et notamment sous son littera a)
9. Décharge pleine et entière est accordée aux organes de la société absorbée.
10. Les documents sociaux de la société absorbée seront conservés pendant le délai légal au siège de la société
absorbante.
11. Dispositions diverses.
Parmi les actifs de la société MENDOCINO S.A. (encore appelée la société absorbée) figurent les participations sui-
vantes:
Mandato fiduciario con Torino Fiduciaria Fiditor Srl No. 05/12 per il seguente bene:
n. 1 quota nominali Euro 26.730,00= (ventiseimilasettecentotrenta/00)
corrispondente al 99% del capitale sociale (Euro 27.000,00) della società
CASTELLO DI LINARI S.R.L in liquidazione
con sede in TORINO, Via Andrea Doria 15
176414
L
U X E M B O U R G
Codice fiscale 11665370158
Mandato fiduciario con Torino Fiduciaria Fiditor Srl No. 06/12 per il seguente bene:
n. 1 quota nominali Euro 10.296,00= (diecimiladuecentonovantasei/00)
corrispondente al 99% del capitale sociale (Euro 10.400,00) della società
PIETRASANTA IMMOBILIARE S.R.L.
con sede in TORINO, Via Andrea Doria 15
Codice fiscale 11665400153
Mandato fiduciario con Torino Fiduciaria Fiditor Srl No. 06/12bis per il seguente bene:
n. 1 quota nominali Euro 9.900,00= (novemilanovecento/00)
corrispondente al 99% del capitale sociale (Euro 10.000,00) della società
ALBERGO PIETRASANTA S.R.L.
con sede in TORINO, Via Andrea Doria 15
Codice fiscale 10827890012
Parmi les actif de la société MENDOCINO S.A. (encore appelée la société absorbée) figurent également des biens
immeubles castrés sous les numéros suivants:
<i>Unità Immobiliari site nel Comune di AZEGLIO(Codice A525) - Catasto dei Fabbricatii>
N.
DATI IDENTIFICATIVI
Sezione Urbana
Foglio
Particella
Sub
1
34
7
2
2
34
7
3
<i>Immobili siti nel Comune di AZEGLIO(Codice A525) - Catasto dei Terrenii>
N.
DATI IDENTIFICATIVI
Foglio
Particella
Sub
1
34
2
2
34
3
3
34
4
4
34
5
5
34
6
<i>Immobili siti nel Comune di SETTIMO ROTTARO(Codice I701) - Catasto dei Terrenii>
N.
DATI IDENTIFICATIVI
Foglio
Particella
Sub
1
11
41
<i>Unità Immobiliari site nel Comune di BORGO D`ALE(Codice B009) - Catasto dei Fabbricatii>
N
DATI IDENTIFICATIVI
Sezione Urbana
Foglio
Particella
Sub
1
1
7
7
<i>Unità Immobiliari site nel Comune di BORGO D`ALE(Codice B009) - Catasto dei Fabbricatii>
N
DATI IDENTIFICATIVI
Sezione Urbana
Foglio
Particella
Sub
1
1
7
9
2
1
7
10
3
1
7
11
4
1
7
12
<i>Unità Immobiliari site nel Comune di BORGO D`ALE(Codice B009) - Catasto dei Fabbricatii>
N.
DATI IDENTIFICATIVI
Foglio
Particella
Sub
1
1
3
2
1
4
176415
L
U X E M B O U R G
A la date effective de la fusion, la société anonyme FINCORP PARTICIPATIONS S.A. (encore appelée la société
absorbante) deviendra propriétaire des actifs ci-dessus mentionnés de la société MENDOCINO S.A. (encore appelée la
société absorbée).
Le notaire soussigné atteste la légalité du présent projet de fusion, conformément aux dispositions de l’article 271 (2)
de la loi sur les sociétés commerciales.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Zianveni et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 17 novembre 2014. LAC/2014/54034 Reçu douze euros (12.- €).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène Thill.
POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 novembre 2014.
Référence de publication: 2014188285/149.
(140210457) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2014.
CIEI, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3230 Bettembourg, 21, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 192.127.
STATUTS
L'an deux mil quatorze, le vingt-et-un novembre;
Par-devant Maître Christine DOERNER, notaire de résidence à Bettembourg;
A comparu:
Madame Helga SCHINTGEN, retraitée, née à Esch/Alzette le 11 mai 1943 (No. Matricule 1943051116855), demeurant
à L-3230 Bettembourg, 21, route d’Esch;
Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant de documenter, ainsi qu’il suit, les statuts d'une société à
responsabilité limitée qu’elle entend constituer:
Art. 1
er
. Il existe une société à responsabilité limitée régie par la loi du 10 août 1915 et la loi du 18 septembre 1933,
telles qu'elles ont été modifiées, et par les présents statuts.
La société peut avoir un associé unique ou plusieurs associés. L'associé unique peut s'adjoindre à tout moment un ou
plusieurs co-associés, et de même les futurs associés peuvent prendre les mesures tendant à rétablir le caractère uni-
personnel de la société.
Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 3. La dénomination de la société est: «CIEI»
Art. 4. La société à pour objet tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu’à l’étranger, pour son propre compte ou pour
le compte de tiers, ou en participation avec ceux-ci, la création, le développement, la fabrication, l’acquisition, la vente et
la commercialisation d’oeuvres, de produits, d’inventions, d’améliorations, d’adaptations, de projets et de procédés de
tous genres et dans tous les domaines, ainsi que la création, le développement, l’exploitation, la valorisation, l’acquisition
et la commercialisation de droits de propriété intellectuelle et industrielle.
La société à comme objet toutes prestations de services et de conseil en rapport avec le présent objet.
Dans le cadre de son activité la société pourra emprunter avec ou sans hypothèque, accorder hypothèque ou se porter
caution pour d’autres personnes morales ou physiques sous réserve des dispositions légales afférentes.
La société a en outre pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière
des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles elle détient un intérêt, tous concours, prêts,
avances ou garanties.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-
nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.
176416
L
U X E M B O U R G
Art. 5. Le siège social est établi dans la commune de Bettembourg. Il peut être transféré à l’intérieur de la commune
du siège par simple décision de l’organe de gérance. Le siège peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché
de Luxembourg ou à l’étranger en vertu d'une décision des associés.
Il peut être créé, par simple décision de l’organe de gérance ou des associés des filiales, succursales ou bureaux, tant
dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l’étranger.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur
la nationalité de la société laquelle, qui, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Art. 6. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500,00.-EUROS), représenté par CENT
VINGT-CINQ (125) parts sociales d’une valeur nominale de CENT EUROS (100,00.- EUROS).
Les parts sociales sont indivisibles et insaisissables.
Au cas où la propriété d’une ou de plusieurs parts sociales est litigieuse ou contestée, le droit de vote de la part sociale
ou des parts sociales concernées est suspendu jusqu’à ce qu’un représentant de cette ou de ces parts sociales soit
communiqué à la société.
Art. 7. Les cessions de parts sociales par l’associé unique sont libres.
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Si un associé se propose de céder tant à titre gratuit qu’à titre onéreux tout ou partie de ses parts sociales à un non-
associé, il doit les offrir préalablement à ses co-associés. L’importance des parts offertes aux co-associés doit se faire
proportionnellement à leur participation dans la société. Ladite offre faite aux co-associés devra se faire au moins six (6)
mois avant la fin de l’exercice en cours.
En cas de désaccord persistant des associés sur le prix après un délai de quatre semaines de la notification de l’offre
de cession aux co-associés, le ou les associés qui entendent céder les parts sociales, le ou les associés qui se proposent
de les acquérir désigneront chacun un expert pour nommer ensuite un autre expert destiné à les départager en cas de
désaccord entre parties pour fixer la valeur de cession, en se basant sur le bilan moyen des trois dernières années et, si
la société ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou des deux dernières année(s).
La société communique par lettre recommandée le résultat de l’expertise aux associés en les invitant à faire savoir
dans un délai de quatre semaines s’ils sont disposés à acheter ou céder leurs parts sociales au prix arrêté. Le silence de
la part des associés pendant ce délai équivaut à un refus. Si plusieurs associés déclarent vouloir acquérir des parts sociales,
les parts sociales proposées à la vente seront offertes aux associés qui entendent les acquérir en proportion de leur
participation dans la société.
L’associé qui entend les céder peut les offrir à des non-associés, étant entendu qu’un droit de préemption est encore
réservé aux autres associés en proportion de leurs participations pendant un délai de deux semaines à partir de la date
de l’offre et suivant les conditions de celle-ci.
Toute cession de parts sociales doit être, sous peine de nullité, acceptée par la société.
Art. 8. Les dispositions de l’article 7 sont applicables à toute aliénation de parts sociales.
La mise en gage ou le nantissement des parts sociales pour raison d’un cautionnement quelconque ainsi que l’apport
des parts sociales comme contre-valeur d’une fraction ou de la totalité du capital, dans le capital d’une société, sont
interdites sans l’accord des associés statuant comme en matière de modification de statuts.
Art. 9. Le décès, l’incapacité, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des
scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront s'en tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilans et inventaires de la
société.
Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément donné
en assemblée générale par la majorité des associés représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.
Le consentement n’est pas requis lorsque les parts sociales sont transmises soit à des héritiers réservataires, soit au
conjoint survivant.
Les héritiers ou les bénéficiaires d’institutions testamentaires ou contractuelles qui n’ont pas été agréés et qui n’ont
pas trouvé un cessionnaire réunissant les conditions requises, peuvent provoquer la dissolution anticipée de la société
trois mois après une mise en demeure signifiée au conseil d’administration par exploit d’huissier et notifiée aux associés
par pli recommandé à la poste.
Toutefois, pendant ledit délai de trois mois, les parts sociales du défunt peuvent être acquises, soit par les associés,
soit par un tiers agréé par eux.
Le prix de rachat des parts sociales se calcule sur la base du bilan moyen des trois dernières années et, si la société
ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou des deux dernières année(s).
176417
L
U X E M B O U R G
S’il n’a pas été distribué de bénéfice, ou s’il n’intervient pas d’accord sur l’application des bases de rachat indiquées par
l’alinéa précédent, le prix sera fixé, en cas de désaccord, par les tribunaux.
Titre 3. - Administration et gérance
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables ad nutum par
l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et les rémunérations. Le ou les gérants sont autorisés à déléguer une partie
ou la totalité de leurs pouvoirs à un ou plusieurs fondés de pouvoirs.
Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appartiennent;
chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire vala-
blement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représentant
les 2/3 du capital social.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.
Art. 14. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Par dérogation, le premier exercice commence le jour de la constitution et finira le trente et un décembre deux mille
quatorze.
Art. 15. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société, le bilan et le compte de profits et pertes, le tout
conformément à l’article 197 de la loi du 18 septembre 1933.
Art. 16. Tout associé peut prendre au siège social communication de l’inventaire et du bilan.
Art. 17. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et des amor-
tissements, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-
ci ait atteint dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition des associés.
Titre 4. - Dissolution - Liquidation
Art. 18. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.
Titre 5. - Dispositions générales
Art. 19. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Souscriptioni>
Les parts sociales ont été souscrites par l’associée unique prénommée.
Toutes les parts ont été entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme DOUZE MILLE
CINQ CENTS EUROS (12.500,00.-EUROS) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, comme il a été
certifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution, à environ mille deux cent cinquante (EUR
1.250,00) euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt, l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social, a pris en sa qualité d’assemblée générale les
résolutions suivantes:
1) L’adresse de la société est établie à 21, route d’Esch, L-3230 Bettembourg.
2) Le nombre de gérants est fixé à un.
3) Est nommé gérant pour une durée indéterminée Madame Helga SCHINTGEN, préqualifiée.
4) La société sera valablement engagée par la signature du gérant unique.
Avant la clôture du présent acte le notaire instrumentaire soussigné a attiré l’attention des constituants sur la nécessité
d’obtenir une autorisation administrative pour exercer les activités décrites dans l’objet social.
176418
L
U X E M B O U R G
DONT ACTE, fait et passé à Bettembourg, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Schintgen, C. Doerner.
Enregistré à Esch/Alzette A.C. le 24 novembre 2014. Relation: EAC/2014/15864. Reçu soixante-quinze euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.
Bettembourg, le 26 novembre 2014.
Référence de publication: 2014188188/155.
(140210732) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2014.
Blue Eagle Portfolios, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 85.241.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 10 novembre 2014i>
En date du 10 novembre 2014, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- d'accepter la démission de Monsieur Eric Attias au 28 mai 2014,
- de renouveler les mandats de Monsieur Arié Assayag, de Monsieur Paulo Baia et de Monsieur Jean-François Vert en
qualité d'Administrateurs jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire prévue en 2015,
- de renouveler le mandat de Ernst & Young S.A. en qualité de Réviseur d'Entreprises jusqu'à la prochaine Assemblée
Générale Ordinaire prévue en 2015.
Luxembourg, le 13 novembre 2014.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Blue Eagle Portfolios
i>Caceis Bank Luxembourg
Référence de publication: 2014176721/18.
(140202631) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2014.
Roof Garden S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 71.607.
L'an deux mille quatorze, le douzième jour du mois de novembre;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné;
S’est réunie
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'“Assemblée”) de la société anonyme régie par les lois du Lu-
xembourg “ROOF GARDEN S.A.”, établie et ayant son siège social à L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 71607 (la “Société”), constituée
originairement sous la dénomination de “NUGGET INTERNATIONAL S.A.”, suivant acte reçu par Maître Léonie GRE-
THEN, notaire alors de résidence à Rambrouch, en remplacement de son collègue Maître Jacques DELVAUX, notaire
alors de résidence à Luxembourg, en date du 25 août 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 889 du 25 novembre 1999,
et dont les statuts (les “Statuts”) ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le
notaire instrumentant, en date du 11 septembre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
2947 du 22 novembre 2013.
L'Assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Roberto PIATTI, expert-comptable, demeurant profession-
nellement à I-20121 Milan, 49, Corso Giuseppe Garibaldi (Italie).
Le Président désigne Madame Nathalie MAGER, employée, demeurant professionnellement à L-1140 Luxembourg,
45-47, route d'Arlon, comme secrétaire.
L'Assemblée choisit Madame Regina ROCHA-MELANDA, employée, demeurant professionnellement à L-1140 Lu-
xembourg, 45-47, route d'Arlon, comme scrutatrice.
Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
A) Que la présente Assemblée a pour ordre du jour:
176419
L
U X E M B O U R G
<i>Ordre du jouri>
1. Réduction du capital à hauteur d'un million d'euros (1.000.000,- EUR) pour le ramener de son montant actuel de
vingt et un millions quatre cent douze mille cent quarante euros (21.412.140,- EUR) à vingt millions quatre cent douze
mille cent quarante euros (20.412.140,- EUR) par annulation de cent mille (100.000) actions d'une valeur nominale de dix
euros (10,- EUR) chacune et remboursement du montant d'un million d'euros (1.000.000,- EUR) aux actionnaires actuels,
l'annulation et le remboursement étant réalisés en proportion de leur participation dans le capital social;
2. Modification subséquente du premier alinéa de l'article 5 des statuts;
3. Modification du registre des actionnaires de la Société afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus avec pouvoir
et autorité donnés à tout administrateur de la Société, agissant individuellement, pour procéder pour le compte de la
Société à l'annulation des actions; et
4. Divers.
B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux, sont
portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux
représentés, les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant.
C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées “ne varietur” par les membres du bureau de l'Assemblée
et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.
D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés,
déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette Assemblée et
renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.
E) Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.
Ensuite l'Assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée décide de réduire le capital social à hauteur d'un million d'euros (1.000.000,- EUR) pour le ramener de
son montant actuel de vingt et un millions quatre cent douze mille cent quarante euros (21.412.140,- EUR) à vingt millions
quatre cent douze mille cent quarante euros (20.412.140,- EUR) par annulation de cent mille (100.000) actions d'une
valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune et remboursement du montant d'un million d'euros (1.000.000,- EUR)
aux actionnaires actuels, l'annulation et le remboursement étant réalisés en proportion de leur participation dans le capital
social.
Tous pouvoirs sont conférés au conseil d'administration pour procéder aux écritures comptables qui s' imposent, à l'
annulation des actions et au remboursement des actionnaires.
DELAI DE REMBOURSEMENT: Le notaire a attiré l'attention de l'Assemblée sur les dispositions de l'article 69 de la
loi sur les sociétés commerciales instaurant une protection en faveur des créanciers éventuels de la Société, le rembour-
sement effectif aux actionnaires ne pouvant avoir lieu librement et sans recours de leur part que 30 (trente) jours après
la publication du présent acte au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution adoptée ci-avant, l'Assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des
statuts afin de lui donner la teneur suivante:
“ Art. 5. (premier alinéa). Le capital social est fixé à vingt millions quatre cent douze mille cent quarante euros
(20.412.140,- EUR), représenté par deux millions quarante et un mille deux cent quatorze (2.041.214) actions d'une valeur
nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.”
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier le registre des actionnaires de la Société afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus
et d'accorder pouvoir et autorité à tout administrateur de la Société, agissant individuellement, pour procéder pour le
compte de la Société à l'annulation des actions, conformément à la première résolution ci-dessus.
Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'Assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés
ne demandant la parole, la Présidente a ensuite clôturé l'Assemblée.
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à mille deux cent cinquante
euros.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits
comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
176420
L
U X E M B O U R G
Signé: R. PIATTI, N. MAGER, R. ROCHA-MELANDA, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 18 novembre 2014. LAC/2014/54290. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
Luxembourg, le 28 novembre 2014.
Référence de publication: 2014190614/88.
(140212273) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2014.
Opportunity Umbrella Fund, Fonds Commun de Placement.
Das abgeänderte Verwaltungsreglement in Bazug auf den Fonds Opportunity Umbrella Fund von 17. November 2014
wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 27. November 2014.
Falcon Fund Management (Luxembourg)
Unterschrift
Référence de publication: 2014190187/11.
(140211906) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2014.
Carnegie Wealth Management Fund Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 192.218.
STATUTES
In the year two thousand and fourteen, on the tenth day of November,
Before us Maître Francis KESSELER, notary, residing in Esch-sur-Alzette, (Grand Duchy of Luxembourg).
THERE APPEARED:
Carnegie Investment Bank AB, with registered office at 56 Regeringsgatan, SE-103 38 Stockholm, Sweden, here re-
presented by Ms. Aisling WHELAN, lawyer, with professional address at 22-24 rives de Clausen, L - 2165 Luxembourg
by virtue of a proxy given in Luxembourg on 30 October 2014, Which proxy, after being signed «ne varietur» by the
party and the undersigned notary, will remain attached to the present deed.
Such appearing party has requested the notary to inscribe as follows the articles of association of a société anonyme
which it forms:
Art. 1. Denomination and Form. There is hereby established, among the subscriber and all those who may become
owners of shares hereafter issued, a corporation in the form of a société anonyme under the name of “CARNEGIE
WEALTH MANAGEMENT FUND SICAV” (the “Company”), qualifying as a Société d’Investissement à Capital Variable
with multiple compartments (SICAV), governed by Part II of the Luxembourg law of 17 December 2010 relating to
collective investment undertakings (the "2010 Law"), as may be amended from time to time, and related Luxembourg
laws and regulations, in particular, the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, (the “1915 Law”),
the law of 12 July 2013 relating to managers of alternative investment funds together with any related laws and regulations
(the “AIFM Law”) and by these articles of association (the “Articles”).
The Company qualifies as an externally managed alternative investment fund within the meaning of the AIFM Law.
Art. 2. Duration. The Company is established for an undetermined duration. The Company may be dissolved by a
resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation (the
“Articles”).
Art. 3. Object. The object of the Company is to place the funds available to it in various permitted assets such as, but
not limited to, transferable securities, investment funds, liquid assets and financial instruments under the broadest meaning
permitted by the 2010 Law, with the purpose of diversifying investment risk and affording its shareholders the benefits
of the management of the Company.
The investment objectives and strategy of the Company are more fully described in the Company's issuing document
(hereinafter referred to as the “Prospectus”).
The Company may take any measures and carry out any operations which it may deem useful to the accomplishment
and development of its purpose to the full extent permitted by the 2010 Law, the AIFM Law and other applicable laws
and in any case, subject to and in accordance with the limits set out in the Prospectus and these Articles.
176421
L
U X E M B O U R G
Art. 4. Registered office. The registered office of the Company is established in Luxembourg in the Grand Duchy of
Luxembourg. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution
of the board of directors of the Company (the “Board of Directors”).
In the event that the Board of Directors determines that extraordinary political, economic or social developments
have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of those abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg corporation.
Art. 5. Capital. The capital of the Company shall at all times be equal to the value of the net assets of all Sub-Funds of
the Company as determined in accordance with Article 17 hereof.
The minimum capital of the Company shall be the equivalent in Swedish Krona of one million two hundred and fifty
thousand euro (EUR 1,250,000) which must be reached within six (6) months following authorisation of the Company
by the Commission de Surveillance du Secteur Financier (the "CSSF") in accordance with the 2010 Law.
The initial subscribed capital is three hundred thousand Swedish Krona (SEK 300 000) divided into three thousand
(3000) fully-paid class IA1 shares of no par value in Carnegie Wealth Management Fund Sicav - Shield Fund The Board of
Directors is authorised to issue additional shares of no par value fully paid up for all Sub-Funds at the respective Net
Asset Value per share determined in accordance with Article 18 hereof without reserving to existing shareholders a
preferential right to subscribe for the shares to be issued.
The Board of Directors may delegate to any duly authorised director or officer of the Company, or to any duly
authorised person, the duties of accepting subscriptions for, receiving payment for and delivering such new shares.
Shares shall be issued in registered form only. Registered share ownership will be evidenced by confirmation of ow-
nership. No share certificates will be issued in respect of registered shares except on specific request.
The Board of Directors may decide to issue one or more classes of shares within each Sub-Fund according to specific
criteria to be determined, such as specific minimum investment amount, specific commissions, charges or fees structure,
dividend policy or other criteria.
The Board of Directors may further decide to create in each class of shares two or more sub-classes whose assets
will be commonly invested pursuant to the specific investment policy of the class concerned but where a specific sales
and redemption charge structure, fee structure, distribution policy or other specificity is applied to each sub-class.
Fractions of shares may be issued with four decimals of a share. Fractions of shares will have no voting rights but will
participate in the distribution of dividends, if any, and in the liquidation distribution.
Upon the issue of different classes or sub-classes of shares, a shareholder may, at his own expense, at any time, request
the Company to convert his shares from one class or sub-class to another class or sub-class based on the relative Net
Asset Value of the shares to be converted (except if restrictions are contained in the Prospectus of the Company.
Art. 6. Sub-Funds. The Board of Directors may establish one or more sub-funds or compartments (“Sub-Funds”),
whose investment objectives may differ and which may be distinguished by the nature of acquired assets, the distinctive
terms of the issues made in their respect, the reference currency or other distinguishing characteristics. Upon the creation
of each additional Sub-Fund, the Prospectus will be updated accordingly. The resolution of the Board of Directors creating
one or more Sub-Funds within the Company, as well as any subsequent amendments hereto, shall be binding as of the
date of such resolutions against any third party.
The Company is a single entity. However, each Sub-Fund corresponds to a separate part of the Company’s assets and
liabilities. The rights of holders of securities issued in respect of a Sub-Fund and the rights of creditors are limited to the
assets of this Sub-Fund, where these rights relate to that Sub-Fund or have arisen at the occasion of the constitution, the
operation or the liquidation of that Sub-Fund. The assets of a Sub-Fund are available exclusively to satisfy the rights of
holders of securities issued in relation to this Sub-Fund and the rights of creditors whose claims have arisen at the occasion
of the constitution, the operation or the liquidation of this Sub-Fund. The holders of securities or the creditors of the
Company whose rights are not related to a specific Sub-Fund of the Company shall have no rights to the assets of any
such Sub-Fund.
In the relationship between the holders of the securities and the creditors, each Sub-Fund is deemed to be a separate
entity.
No resolution of the Board of Directors may amend the resolution creating such Sub-Fund or directly affect the rights
of the holders of securities or the creditors whose rights relate to such Sub-Fund without the prior approval of the
holders of securities and creditors whose rights relate to such Sub-Fund.
Any decision of the Board of Directors taken in breach of this provision shall be void.
Without prejudice to what is stated above, each Sub-Fund of the Company may be separately liquidated without such
liquidation resulting in the liquidation of another Sub-Fund of the Company.
For purposes of determining the share capital of the Company, the Company's share capital shall be the aggregate of
the net assets of all of the Sub-Funds.
176422
L
U X E M B O U R G
Art. 7. Restrictions. In the interest of the Company, the Board of Directors may restrict or prevent the ownership of
shares in the Company by any physical person or legal entity.
Art. 8. Meetings. Any regularly constituted meeting of the shareholders of this Company shall represent the entire
body of shareholders of the Company.
The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the
registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on
the third Friday in April of each year, at 10:00 (local time) local time and for the first time in 2016. If such day is a bank
holiday in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following bank business day. A “bank business
day” means any day where the banks are open in Luxembourg. The annual general meeting may be held outside of
Luxembourg, if, in the absolute and final judgement of the Board of Directors, exceptional circumstances so require.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of
meeting.
All meetings shall be convened in the manner provided for by Luxembourg law.
Each share in whatever Sub-Fund regardless of the Net Asset Value per share within the Sub-Fund is entitled to one
vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person (who need not be a shareholder
and who may be a director of the Company) as his proxy, which appointment shall be in writing or in the form of a cable,
telegram, telex, telefax or similar communication.
Resolutions concerning the interests of the shareholders of the Company shall be taken in a general meeting and
resolutions concerning the particular rights of the shareholders of one specific Sub-Fund shall be taken by this Sub-Fund's
general meeting.
Except as otherwise provided herein or required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will
be passed by a simple majority of those present and voting.
The Board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders, including, without
limitation, conditions of participation in meetings of shareholders.
Art. 9. Board of Directors. The Company shall be managed by a Board of Directors composed of not less than three
members who need not be shareholders of the Company.
The directors shall be elected by the shareholders at their annual meeting for a period ending at the next annual general
meeting and shall hold office until their successors are elected. A director may be removed with or without cause and
replaced at any time by resolution adopted by the shareholders.
In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors
may meet and elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next meeting of the shareholders.
Art. 10. Chairman. The Board of Directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from
among its members one or more vice-chairmen. It may also choose a secretary who need not be a director, who shall
be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors and of the shareholders. The Board of
Directors shall meet upon call by the chairman, or any director, at the place indicated in the notice of meeting. The
chairman shall preside at all meetings of shareholders or in his absence or inability to act, the vice-chairman or another
director appointed by the Board of Directors shall preside as chairman pro-tempore, or in their absence or inability to
act, the shareholders may appoint another director or an officer of the Company as chairman pro-tempore by vote of
the majority of shares present or represented at any such meeting.
The chairman shall preside at all meetings of the Board of Directors, or in his absence or inability to act, the vice-
chairman or another director appointed by the Board of Directors shall preside as chairman pro-tempore.
The Board of Directors from time to time shall appoint the officers of the Company, including officers considered
necessary for the operation and management of the Company, who need not be directors or shareholders of the Com-
pany. The officers appointed unless otherwise stipulated in these Articles, shall have the power and duties given them by
the Board of Directors.
Written notice of any meeting of the Board of Directors shall be given to all directors at least 24 hours in advance of
the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances shall
be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by consent in writing or by cable, telegram, telex, telefax
or similar communication from each director.
Separate notices shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule pre-
viously adopted by resolution of the Board of Directors.
Any director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing another director as proxy, which ap-
pointment shall be in writing or in form of a cable, telegram, telex, telefax or similar communication.
The Board of Directors can deliberate or act with due authority if at least a majority of the directors is present or
represented at such meeting. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented
at such meeting. In the event that in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the
chairman shall have a casting vote.
176423
L
U X E M B O U R G
Any member of the Board of Directors who participates in the proceedings of a meeting of the Board of Directors
by means of a communications device (including a telephone or video conference) which allows all the other members
of the Board of Directors present at such meeting (whether in person, or by proxy, or by means of such communications
device) to hear and to be heard by the other members at any time shall be deemed to be present in person at such
meeting, and shall be counted when reckoning a quorum and shall be entitled to vote on matters considered at such
meeting. Members of the Board of Directors who participate in the proceedings of a meeting of the Board of Directors
by means of such communications device shall ratify their votes so cast by signing one copy of the minutes of the meeting.
Resolutions signed by all members of the Board of Directors will be as valid and effectual as if passed at a meeting duly
convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution and
may be evidenced by letter, cable, telegram, telex, telefax or similar communication.
Art. 11. Minutes. The minutes of any meeting of the Board of Directors shall be signed by the chairman, or in his
absence, by the chairman pro-tempore who presided at such meeting or by two directors.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the
chairman or by the chairman pro-tempore of that meeting, or by two directors or by the secretary or an assistant
secretary.
Art. 12. Powers. The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration,
disposition and execution in the Company's interest. All powers not expressly restricted by law or by the present Articles
to the general meeting of shareholders fall within the competence of the Board of Directors.
The Board of Directors, applying the principle of the risk spreading, is authorised to determine the Company's and
each of its Sub-Fund’s investment policy in compliance with the relevant legal provisions and the object set out in Article
3 hereof.
A Sub-Fund of the Company, may, subject to the conditions provided for in the Prospectus of the Company and to
the conditions of the 2010 Law, subscribe, acquire and/or hold securities to be issued by one or more Sub-Funds of the
Company.
Art. 13. Invalidity. No contract or other transaction between the Company and any other corporation or entity shall
be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested in,
or is a director, officer or an employee of such other corporation or entity, provided, however, that the Company shall
not knowingly purchase or sell portfolio investments from or to any of its officers or directors, or to any entity in which
such officers or directors hold 10 % or more of the issued shares.
Art. 14. Indemnity. The Company may indemnify any director or officer, and his heirs, executors and administrators,
against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made
a party by reason of his being or having been a director or officer of the Company or, at its request, of any other fund
of which the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation
to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or
misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered
by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such
a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.
Art. 15. Delegation. The Board of Directors shall delegate its powers to conduct the daily management and affairs of
the Company (including the right to act as an authorised signatory for the Company) to an externally appointed mana-
gement company who shall be either registered or authorised as an alternative investment fund manager within the
meaning of the AIFM Law.
The Board of Directors may also delegate its powers to carry out acts in furtherance of the corporate policy and
purpose to officers of the Company or third parties who may, if the Board of Directors so authorizes, re-delegate such
powers in turn.
Art. 16. Signatures. The Company will be bound by the joint signatures of any two directors or by the joint signatures
of any director and any duly authorised officer, or by the individual signature of any director or agent of the Company
duly authorised for this purpose, or by the individual signature of any person to which a special power has been delegated
by the Board of Directors, but only within the limits of such powers.
Art. 17. Redemption and Conversion of shares. As is more specifically described herein below, the Company has the
power to redeem its own outstanding fully paid shares at any time, subject solely to the limitations set forth by law.
A shareholder of the Company may at any time irrevocably request the Company to redeem all or any part of his
shares of the Company. In the event of such request, the Company shall redeem such shares subject to any suspension
of this redemption obligation pursuant to Article 18 hereof. Shares of the capital stock of the Company redeemed by the
Company shall be cancelled.
The shareholder will be paid a price per share based on the Net Asset Value for the relevant class of the relevant Sub-
Fund as determined in accordance with the provisions of Article 18 hereof less a redemption commission such as
determined by the Board of Directors from time to time, as more fully described in the Prospectus.
176424
L
U X E M B O U R G
If a redemption application is to be executed at the Net Asset Value per share prevailing on a Valuation Date, the
application form must be received by the Company by no later than such a cut-off time as determined by the Board of
Directors. Any application received after such time will be executed on the basis of the Net Asset Value calculated on
the next following Valuation Date.
Payment to a shareholder under this Article will be made by bank transfer in the relevant currency of the Sub-Fund
or in any other freely convertible currency at the choice and expense of the shareholder and shall be dispatched within
five bank business days after the relevant Valuation Date and after receipt of the proper documentation. If market con-
ditions permit, the Company may pay individual redemption requests “in-kind” provided the redemption request is greater
than such amount determined from time to time by the Board of Directors. In such case, the independent auditor of the
Company shall establish a report to value the payment in kind, the expenses of which shall be borne either by the
shareholder who has chosen this method of payment or by the Portfolio Manager, if so agreed. The Board of Directors
may furthermore subject such payment to other terms and conditions such as specified in the Prospectus.
Any request must be filed by such shareholder in irrevocable, written form at the registered office of the Company in
Luxembourg, or at the office of the person or entity designated by the Company as its agent for the repurchase of shares,
such request in the case of shares for which a certificate has been issued to be accompanied by the certificate or certificates
for such shares in proper form or by proper evidence of succession or assignment satisfactory to the Company.
Any shareholder may request the conversion of the whole or part of his shares, with a minimum amount of shares
which shall be determined by the Board of Directors from time to time, into another class of shares of the same Sub-
Fund or of any other Sub-Fund provided that the conditions of access to a specific class of shares as described in the
prospectus are fulfilled. If a conversion application is to be executed at the Net Asset Value per share prevailing on a
Valuation Date, the application form must be received by the Company by no later than such a cut-off time as specified
by the Board of Directors. Any application received after such time will be executed on the basis of the Net Asset Value
calculated on the next following Valuation Date.
Conversion of shares into shares of any other Sub-Fund will only be made if the Net Asset Value of both Sub-Funds
is calculated on the same day. A conversion commission may be charged, such as determined by the Board of Directors
from time to time, as more fully described in the Prospectus.
Shareholders may also be requested to bear the difference in the issue commission between the class of shares of the
Sub-Fund they leave and the class of shares of the Sub-Fund of which they become shareholders, should the issue com-
mission of the class of shares of the Sub-Fund into which the shareholders are converting their shares be higher than the
issue commission of the class of shares of the Sub-Fund they leave.
In the event that applications for redemption and/or conversion exceed a certain percentage of the net asset value of
a Sub-Fund’s shares, which percentage shall be determined from time to time by the Board of Directors and shall be
disclosed in the Prospectus, the Company may postpone the conversion and/or redemption of all or part of such shares
to the following Valuation Date. On the following Valuation Date such requests will be dealt with in priority to any
subsequent requests for conversion and/or redemption.
Art. 18. Net Asset Value. Whenever the Company shall issue, redeem and convert shares of the Company, the price
per share shall be based on the Net Asset Value of the shares as defined herein.
The Net Asset Value of the shares in each class of each Sub-Fund shall be determined by the Company or its agent
from time to time, but subject to the provisions of the next following paragraph, in no instance less than once a month
on a bank business day or days in Luxembourg (every such day or time for determination of Net Asset Value referred
to herein a “Valuation Date”).
The Company may at any time and from time to time suspend the calculation of the Net Asset Value of the shares of
any class of any Sub-Fund and the issue, the redemption and the conversion thereof in the following instances:
- during any period (other than ordinary holidays or customary weekend closings) when any market or stock exchange
is closed, which is the main market or stock exchange for a significant part of the Sub-Fund's investments, or in which
trading therein is restricted or suspended; or
- during any period when an emergency exists as a result of which it is impossible to dispose of investments that
constitute a substantial portion of the assets of a Sub-Fund; or
- during any breakdown in the means of communication normally employed in determining the price of any of the Sub-
Fund's investments or of current prices on any stock exchange; or
- when for any reason the prices of any investment owned by the Sub-Fund cannot, under the control and liability of
the Board of Directors, be reasonably, promptly or accurately ascertained; or
- during the period when remittance of monies that will or may be involved in the purchase or sale of any of the Sub-
Fund's investments cannot, in the opinion of the Board of Directors, be carried out at normal rates of exchange; or
- following a decision to liquidate or dissolve the Company or one or several Sub-Funds; or
- whenever exchange or capital movement restrictions prevent the execution of transactions on behalf of the Company
or in case purchase and sale transactions of the Company's assets are not realisable at normal exchange rates; or
176425
L
U X E M B O U R G
- during any period when the net asset value of one or more UCI, in which a Sub-Fund has invested and the units or
the shares of which constitute a significant part of the assets of the Sub-Fund, cannot be determined accurately so as to
reflect their fair market value as at the Valuation Date.
The suspension of the calculation of the Net Asset Value and of the issue, conversion and redemption of the shares
shall be published in a Luxembourg newspaper and in one newspaper of more general circulation.
Any such suspension shall be notified to the existing shareholders, as well as to the shareholders requesting subscrip-
tion, conversion or redemption of shares on the day following their request. Pending subscription, conversion and
redemption requests can be withdrawn after written notification as long as these notifications reach the Company before
the end of the suspension. Pending requests will be considered on the first Valuation Date following the end of the
suspension.
In the case where the calculation of the Net Asset Value is suspended for a period exceeding one month all shareholders
will be personally notified.
The Net Asset Value of the shares of each class of each Sub-Fund shall be expressed in the currency of the relevant
Sub-Fund as a per share figure and shall be determined on any Valuation Date by dividing the value of the net assets of
that Sub-Fund to be allocated to such class of shares, being the value of the assets of that class of shares of that Sub-Fund
less its liabilities at the time determined by the Board of Directors or its duly authorised designee on the Valuation Date,
by the number of shares of the class of the relevant Sub-Fund then outstanding (the “Net Asset Value”).
The valuation shall be effected in the following manner:
A) The assets of each Sub-Fund shall include:
a) all cash in hand and on deposit including interest due but not yet collected and interest accrued on these deposits
up to the Valuation Date;
b) all bills and demand notes and all accounts receivable, (including proceeds from the sale of securities for which the
price has not yet been received);
c) all securities, units, shares, debt securities, option and subscription rights and other investments and transferable
securities which are owned by the Company;
d) all dividends and distributions declared to be received by the Company in cash or in securities insofar as the Company
is aware of the same;
e) all interest due but not yet received and all interest yielded up to the Valuation Date by securities owned by the
Company unless, however, such interest is included in the principal amount of said securities;
f) the incorporation expenses of the Company if such were not amortised, and
g) all other assets of any kind whatsoever including any expenses paid in advance.
The value of the assets of each class of share of each Sub-Fund is determined as follows:
1) The value of any cash at hand or on deposit, bills and demand notes and accounts receivable, prepaid expenses,
dividends and interests declared or due but not yet collected will be deemed to be the full value thereof, unless it is
unlikely that such values are received in full, in which case the value thereof will be determined by deducting such amount
the directors consider appropriate to reflect the true value thereof.
2) Securities and money market instruments admitted to official listing on a stock exchange or which are traded on
another regulated market which operates regularly and is recognised and open to the public are valued at the last available
price on such stock exchange or market. If the same security or money market instrument is quoted on different markets,
the quotation of the main market for this security or money market instrument will be used;
3) Securities or money market instruments not listed on any stock exchange or traded on any regulated market or
securities or money market instruments for which no price quotation is available or for which the price referred to in
(2) is not representative of the fair market value, will be valued prudently, and in good faith on the basis of their reasonable
foreseeable sales prices;
4) investments in investment funds of the open-ended type are taken at their latest net asset values reported by the
administrator of the relevant investment fund;
5) Futures and options are valued on the basis of their closing price on the concerned market on the preceding day.
The prices used are the liquidation prices on the futures markets;
6) Swaps are valued at their real value, which is based on the last known traded closing price of the underlying security.
In addition, appropriate provisions will be made to account for the charges and fees levied on the Sub-Funds.
Assets expressed in a currency other than the currency of the relevant Sub-Fund shall be converted on the basis of
the rate of exchange ruling on the relevant business day in Luxembourg.
In the event it is impossible or incorrect to carry out a valuation in accordance with the above rules owing to particular
circumstances, the Board of Directors or its designee is entitled to use other generally recognised valuation principles,
which can be examined by an auditor, in order to reach a proper valuation of each Sub-Fund's total assets.
B) The liabilities of the Company shall be deemed to include:
a) all borrowings, bills matured and accounts payable;
176426
L
U X E M B O U R G
b) all known liabilities, whether or not due, including all matured contractual commitments where such commitments
involve a payment either in cash or in kind, including the amount of dividends declared but not paid by the Company if
the Valuation Date coincides with the date at which the persons who are or will be entitled to such dividends are
determined;
c) all reserves, authorised or approved by the directors, in particular those that have been built up to reflect a possible
depreciation on some of the Company’s assets;
d) all other commitments of the Company of any kind whatsoever other than commitments represented by the shares
of the Company. For the purpose of estimating the amount of such commitments the Company shall take into account
all of its payable expenses such as described in Article 20 of these Articles including, without any limitation, all taxes levied
on the assets and the income of the Company (in particular, but not limited to, the “taxe d’abonnement” and any stamp
duties payable), fees for legal and auditing services, costs of any proposed listings and of maintaining such listings, pro-
motion, printing, reporting and publishing expenses (including reasonable marketing and advertising expenses) of
prospectuses, KIIDs, addenda, explanatory memoranda, registration statements, global note if any, annual reports and
semi-annual reports, all reasonable out-of-pocket expenses of the directors, all taxes levied on the assets, registration
fees and other expenses payable to governmental and supervisory authorities in any relevant jurisdictions, insurance costs,
costs of extraordinary measures carried out in the interests of shareholders (in particular, but not limited to, arranging
expert opinions and dealing with legal proceedings) and all other operating expenses, including fees payable to trustees,
fiduciaries, correspondent banks and local paying agents and any other agents employed by the Company, the cost of
buying and selling assets, customary transaction fees, commissions and compliance fees charged by depositary banks or
their agents (including free payments and receipts and any reasonable out-of-pocket expenses, i.e. stamp taxes, registration
costs, scrip fees, special transportation costs, etc.), customary brokerage fees and commissions charged by banks and
brokers for securities transactions and similar transactions, interest and postage, telephone, facsimile, telex charges and
all the costs related to securities lending transactions (agency fees and transactions costs), shall be borne by the Company
and all other administrative costs. For the purpose of estimating the amount of such liabilities, the Company may factor
in any regular or recurrent administrative and other expenses on the basis of an estimate for the year or any other period
by dividing the amount in proportion to the fractions of such period.
C) The Board of Directors shall establish a portfolio of assets for each Sub-Fund, and for one or more classes of shares
if such classes were issued in accordance with Article 5 of these Articles, in the manner prescribed hereafter.
a) the proceeds from the issue of the shares of each Sub-Fund shall be attributed, in the books of the Company, to
the portfolio of assets established for such Sub-Fund, it being understood that if a portfolio of assets is established for
one or more classes of shares as indicated above, the following rules shall apply mutatis mutandis to such classes of shares,
and the assets, liabilities, income and expenses relating to such Sub-Fund or such classes of shares shall be attributed to
this portfolio of assets in accordance with the provisions of this Article;
b) if an asset derives from another asset, such derived asset shall be attributed, in the books of the Company, to the
same portfolio to which the asset generating it belongs and at each revaluation of an asset, the increase or reduction in
value shall be attributed to the portfolio to which such asset belongs;
c) when the Company pays any liability which relates to an asset of a given portfolio or relates to an operation carried
out in connection with an asset of a given portfolio, this liability shall be attributed to the portfolio in question;
d) if an asset or liability of the Company may not be attributed to a given collection, such asset or liability shall be
attributed to all the portfolios in proportion to the net values of the various Sub-Funds;
it being understood that:
1) all unsubstantial amounts may be apportioned between all the portfolios; and
2) the Board of Directors may allocate expenses, after having consulted the Company’s auditor, in an equitable and
reasonable manner while taking into account all the circumstances; and
3) the directors may reattribute an asset or liability previously attributed if they deem that such is required by the
circumstances.
D) For the purposes of this Article
a) the shares for which subscriptions have been accepted but for which payment has not yet been received, shall be
regarded as existing as from the close of the Valuation Date on which their price was determined. The price, until it is
received by the Company, shall be regarded as a claim of the Company;
b) each share of the Company which is in the process of being repurchased in accordance with Article 17 above, shall
be regarded as an issued and existing share until after the close of the aforesaid Valuation Date and shall, as from such
day and until the price thereof is paid, be regarded as a liability of the Company;
c) all investments, cash balances or other assets of the Company which are not expressed in the Sub-Fund’s reference
currency shall be valued after taking into account the current exchange rates at the day and time the value of the shares
is determined and
d) as far as possible, any purchase or sale of transferable securities contracted by the Company shall take effect on the
Valuation Date.
176427
L
U X E M B O U R G
In the absence of bad faith, gross negligence or manifest error, every decision taken by the Board of Directors or by
a designee of the Board of Directors in calculating the Net Asset Value, shall be final and binding on the Company, and
present, past or future shareholders. The result of each calculation of the Net Asset Value shall be certified by a director
or a duly authorised representative or a designee of the Board of Directors.
The percentage of the total Net Asset Value allocatable to each class of shares of each Sub-Fund shall be determined
on the establishment of the Company by the ratio of the shares issued in each class of each Sub-Fund to the total number
of shares issued and shall be adjusted subsequently in connection with the distributions effected and the issue and re-
demption of shares as follows:
1. On each occasion when in a Sub-Fund a distribution is effected on distribution classes of shares, the Net Asset Value
of the shares in the class shall be reduced by the amount of the distribution (causing a reduction in the percentage of Net
Asset Value allocatable to the shares of this class), whereas the Net Asset Value of accumulation class shares shall remain
unchanged (causing an increase in the percentage of Net Asset Value allocatable to accumulation class shares).
2. On each occasion when shares are issued or redeemed, the Net Asset Value allocatable to the corresponding class
of shares shall be increased or reduced by the amount received or paid out by the Company.
In addition, appropriate provisions will be made to account for the charges and fees charged to the Sub-Funds as well
as accrued income on investments.
In the event it is impossible or incorrect to carry out a valuation in accordance with the above rules owing to ex-
traordinary circumstances or events, the Board of Directors may use other generally-recognised valuation principles,
which can be examined by an auditor, in order to reach a proper valuation of each Sub-Fund's total assets.
Art. 19. Issuance of shares. Whenever shares of the Company shall be offered by the Company for subscription, the
price per share at which such shares shall be issued shall be based on the Net Asset Value thereof as determined in
accordance with the provisions of Article 18 hereof. The Board of Directors may also decide that an issue commission
and or a transaction fee and/or an account opening fee have to be paid.
Allotment of shares shall be made upon subscription and is conditional upon receipt by the Company of notification
of receipt of the full settlement amount.
The subscription price is payable by wire transfer within three (3) bank business days following the relevant Valuation
Date. The Board of Directors may in its discretion determine the minimum amount of any subscription in any Sub-Fund.
If a subscription application is to be executed at the Net Asset Value per share prevailing on a Valuation Date, the
application form must be received by the Company by no later than such a cut-off time as determined by the Board of
Directors. Any application received after such time will be executed on the basis of the Net Asset Value calculated on
the next following Valuation Date.
The Company may also accept securities as payment of the shares provided that the securities meet the investment
policy and investment restrictions of the concerned Sub-Fund of the Company. In such case, the independent auditor of
the Company shall establish a report to value the contribution in kind, the expenses of which shall be borne either by
the subscriber who has chosen this method of payment or by the Portfolio Manager, if so agreed. The Board of Directors
may furthermore subject the acceptance of such payment to other terms and conditions such as specified in the sales
documentation of the Company.
The Board of Directors may, if it thinks appropriate, may close a Sub-Fund of the Company to new subscriptions.
Art. 20. Expenses. The Company shall bear the fees due to the Depositary Bank, the management company as well as
to any service provider appointed by the Board of Directors from time to time.
Moreover, the Company shall also bear the following expenses:
- all taxes which may be payable on the assets, income and expenses chargeable to the Company;
- standard brokerage fees and bank charges incurred by the Company's business transactions;
- all fees due to the Auditor and the Legal Counsel to the Company;
- all expenses connected with publications and supply of information to shareholders, in particular, the cost of printing
and distributing the annual financial report and the prospectus;
- all expenses involved in registering and maintaining the Company registered with all governmental agencies and stock
exchanges;
- all expenses incurred in connection with its incorporation, operation and its management.
All recurring expenses will be charged first against current income, then, should this not suffice, against realised capital
gains, and, if necessary, against assets.
Any costs, which are not attributable to a specific Sub-Fund incurred by the Company will be charged to all Sub-Funds
in proportion to their net assets.
Each Sub-Fund will be charged with all costs and expenses directly attributable to it. Each Sub-Fund shall be liable
towards its creditors for its own debts and obligations. For the purpose of the relations between the shareholders, each
Sub-Fund will be deemed to be a separate entity with, but not limited to, its own contribution, capital gains, losses, charges
and expenses.
176428
L
U X E M B O U R G
Each new Sub-Fund shall amortize its own expenses of establishment over a period of five years as of the date of its
creation.
Art. 21. Fiscal Year and Financial Statements. The fiscal year of the Company shall start on the 1
st
of January each
year and shall terminate on the 31
st
day of December each year. The first year shall start on the day of the incorporation
of the Company and shall end on the 31
st
day of December 2015.
Financial statements for each Sub-Fund shall be established in the currency in which it is denominated. To establish
the balance sheet of the Company, those different financial statements will be added after conversion into the currency
of the capital of the Company which is SEK.
Art. 22. Auditor. The Company shall appoint an Auditor who shall carry out the duties prescribed by law. The Auditor
shall be elected by the annual general meeting and shall remain in office until his successor is elected.
Art. 23. Dividends. The general meeting of shareholders shall determine how the profits (including net realised capital
gains) of the Company shall be disposed of and may from time to time declare, or authorize the Board of Directors to
declare dividends, provided that the net assets of any Sub-Fund do not fall below the equivalent in Swedish Krona of EUR
1,250,000.-. Dividends declared will be paid in the Sub-Fund’s reference currency, or in shares of the Company and may
be paid at such places and times as may be determined by the Board of Directors.
The annual general meeting of shareholders shall decide, on recommendation of the Board of Directors, what portion
of the Sub-Funds’ profits shall be distributed.
The net income allocated to distribution classes of shares shall be available for distributions to holders of such shares.
The net income allocated to accumulation classes of shares shall be added to the portion of net assets corresponding to
that class of shares.
Art. 24. Liquidation, merger or contribution of a Sub-Fund or liquidation of the Company. In the event of dissolution
of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal
entities) named by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which shall determine their powers and
their compensation.
In the event of any contemplated liquidation of the Company, no further issue, conversion or redemption of shares
will be permitted after publication of the first notice convening the extraordinary meeting of shareholders for the purpose
of winding-up the Company. All shares outstanding at the time of such publication will participate in the Company's
liquidation distribution. The net proceeds of liquidation corresponding to each Sub-Fund shall be distributed to the holders
of shares in that Sub-Fund in proportion to their holdings of shares in that Sub-Fund.
A Sub-Fund may be terminated by resolution of the Board of Directors of the Company if the Net Asset Value of a
Sub-Fund is below such amount as determined by the Board of Directors from time to time or in the event of special
circumstances beyond its control, such as political, economic, military emergencies, or if the Board of Directors should
conclude, in light of prevailing market or other conditions, including conditions that may adversely affect the ability of a
Sub-Fund to operate in an economically efficient manner, and with due regard to the best interests of shareholders, that
a Sub-Fund should be terminated. In such events, the assets of the Sub-Fund will be realised, the liabilities discharged and
the net proceeds of realization distributed to shareholders in the proportion to their holding of shares in that Sub-Fund.
In such event, notice of the termination of the Sub-Fund will be given in writing to registered shareholders and will be
published, if necessary, in any newspapers as determined from time to time by the Board of Directors. No shares shall
be redeemed or converted after the date of the decision to liquidate a Sub-Fund.
A Sub-Fund may be merged with another Sub-Fund of the Company or with the Sub-Fund of another entity by reso-
lution of the Board of Directors if the value of its net assets falls below an amount determined by the Board of Directors
to be the minimum level for such Sub-Fund to be operated in an economically efficient manner, or if a change in the
economic or political situation relating to the Sub-Fund concerned would justify such merger, or if necessary in the
interests of the shareholders or the Company. Notice of merger will be given in writing to registered shareholders. Each
shareholder of the relevant Sub-Funds shall be given the possibility, within a period of one month as of the date of the
notice, to request either the repurchase of its shares, free of any charges, or the conversion of its shares, free of any
charges, against shares of Sub-Funds not concerned by the merger. At the expiry of this 1 (one) month's period any
shareholder who did not request the repurchase or the conversion of its shares, shall be bound by the decision relating
to the merger.
A Sub-Fund may be contributed to another Luxembourg investment fund organised under Part II of the 2010 Law by
resolution of the Board of Directors in the event of special circumstances beyond its control such as political, economic
or military emergencies or if the Board should conclude, in light of prevailing market or other conditions, including
conditions that may adversely affect the ability of a Sub-Fund to operate in an economically efficient manner, and with
due regard to the best interests of the shareholders, that a Sub-Fund should be contributed to another fund. In such
events, notice will be given in writing to registered shareholders and will be published in such newspapers as determined
from time to time by the Board of Directors. Each shareholder of the relevant Sub-Fund shall be given the possibility
within a period to be determined by the Board of Directors, but not being less than one month, and published in said
176429
L
U X E M B O U R G
newspapers to request, free of any charge, the repurchase or conversion of its shares. At the close of such period, the
contribution shall be binding for all shareholders who did not request a redemption or a conversion.
In the case of a contribution to a mutual fund, however, the contribution will be binding only on shareholders who
expressly agreed to the contribution. When a Sub-Fund is contributed to another Luxembourg investment fund, the
valuation of the Sub-Fund’s assets shall be verified by the auditor of the Company who shall issue a written report at the
time of the contribution.
A Sub-Fund may be contributed to a foreign investment fund only when the relevant Sub-Fund’s shareholders have
unanimously approved the contribution or on the condition that only the shareholders who have approved such contri-
bution are effectively transferred to that foreign fund.
Art. 25. Amendment. These Articles may be amended from time to time by a meeting of shareholders, subject to the
quorum and voting requirements provided by the laws of Luxembourg.
Art. 26. Applicable law. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the 1915
Law, as well as the 2010 Law and the AIFM Law.
<i>Statementi>
The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the 1915 Law have been
fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.
<i>Subscription and paymenti>
The Articles having thus been established, the appearing party declares to subscribe the shares as follows:
Carnegie Investment Bank AB prenamed, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3000 class IA1 shares in Carnegie Wealth
Management Fund Sicav - Shield Fund
TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3000 class IA1 shares in Carnegie Wealth
Management Fund Sicav - Shield Fund
All these shares have been fully paid up by payments in cash so that the sum of three hundred thousand Swedish Krona
(SEK 300 000) is forthwith at the free disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who
certifies it.
<i>Estimates of costsi>
The party has estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the
Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, at 3,000.- Euro.
<i>Extraordinary general meetingi>
Here and now, the above-named person, representing the entire subscribed capital and considering itself as duly
convoked, has proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly constituted,
it has passed the following resolutions:
1) The registered office of the Company is fixed at L-1616 Luxembourg, Centre Europe, 5 Place de la Gare.
2) The number of directors is set at four (4) and that of the auditor at one (1).
3) The following are appointed directors, their mandates expiring at the issue of the annual general meeting which is
to be held in 2016:
(a) Mrs Karin Birgitta SÖDERQVIST LINDOFF, born in Sudsvall, Sweden on 19 April 1962, Head of Private Banking,
CARNEGIE INVESTMENT BANK AB,with professional address at 56, Regeringsgatan, SE-103 38 Stockholm, Sweden;
(b) Mr Brian Daniel CORDISCHI, born in Haverhill, Massachusetts, U.S.A. on 20 February 1963, CIO & Head of
Investment Strategy, CARNEGIE INVESTMENT BANK AB, with professional address at 56, Regeringsgatan, SE-103 38
Stockholm, Sweden;
(c) Mrs Asa Christine SUNDBERG, born in Örebro, Sweden on 23 November 1965, Legal Counsel, CARNEGIE
INVESTMENT BANK AB, with professional address at 56, Regeringsgatan, SE-103 38 Stockholm, Sweden; and
(d) Mr Stephan KARLSTEDT, born in Stockholm, Sweden on 12 January 1968, General Manager, CARNEGIE FUND
SERVICES S.A., with professional address at 5, Place de la Gare, L-1616 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
4) The following has been appointed auditor, its mandate expiring at the issue of the annual general meeting which is
to be held in 2016:
PricewaterhouseCoopers S.à r.l.
400, route d’Esch
L-1471 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the above named
person, this deed is worded in English, availing of the derogation set out in article 26(2) of the 2010 Law whereby as the
176430
L
U X E M B O U R G
deed recording these amendments to the Articles of the Company is in English, the attachment of a translation into an
official language to this deed when filed with the registration authorities does not apply.
Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.
This deed having been read to the appearing person, known to the notary by its name, Christian name, civil status and
residence, said person appearing signed together with us, the notary, this original deed.
Signé: Whelan, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 12 novembre 2014. Relation: EAC/2014/15286. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. Halsdorf.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2014190969/559.
(140212714) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2014.
KDC Investments Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 6.574.000,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippman.
R.C.S. Luxembourg B 189.975.
In the year two thousand and fourteen, on the twentieth day of October.
Before Maître Roger Arrensdorff, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
There appeared:
3147014 Nova Scotia Company, a company incorporated and organized under the laws of the Province of Nova Scotia,
having its registered office at Suite 900, 1959 Upper Water Street, Halifax, NS Canada, B3J 3N2, registered with the
Registry of Joint Stock Companies under number 3147014, acting through its Luxembourg branch, KDC Investments,
Luxembourg Branch, having its registered office at L-5365 Munsbach, 6C rue Gabriel Lippmann, registered with the
Luxembourg trade and companies register under number B 189.756 (the “Sole Member”);
duly represented by Matthieu Groetzinger, lawyer, residing at L-2132 Luxembourg, 20 avenue Marie-Thérèse, by virtue
of a proxy dated October 20, 2014.
The said proxy, after having been signed “ne varietur” by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and
the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing person, acting in the here above stated capacity, requested the undersigned notary to:
I. state that KDC Investments, Luxembourg Branch is the Sole Member of KDC Investments Luxembourg Sàrl, a private
limited liability company (“société à responsabilité limitée”), having its registered office at L-5365 Munsbach, 6C rue
Gabriel Lippmann, registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 189.975, incorporated
by a deed received by Maître Roger Arrensdorff, notary residing in Luxembourg on August 22, 2014, not yet published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the “Company”).
II. record the following resolutions which have been taken in the best corporate interest of the Company, according
to the agenda below:
<i>Agendai>
1. Increase of the corporate capital of the Company by an amount of USD 6,544,000.- (six million five hundred and
forty-four thousand US dollars) so as to bring it from its current amount of USD 30,000.- (thirty thousand US dollars),
represented by 30 (thirty) ordinary shares and 0 (zero) mandatory redeemable preferred shares (the “MRPS”) having a
par value of USD 1,000.- (one thousand US dollars) each, to the amount of USD 6,574,000.- (six million five hundred and
seventy-four thousand US dollars) by the issue of 6,544.- (six thousand five hundred and forty-four) MRPS with a par
value of USD 1,000.- (one thousand US dollars) each;
2. Allocation of the amount of USD 657,400.- (six hundred and fifty-seven thousand four hundred US dollars) to the
legal reserve of the Company.
3. Subscription and payment of all additional issued MRPS together with the payment of a share premium attached to
the MRPS of USD 58,239,725.- (fifty-eight million two hundred and thirty-nine thousand seven hundred and twenty-five
US dollars) and the allocation of the amount of USD 657,400.- (six hundred and fifty-seven thousand four hundred US
dollars) to the legal reserve of the Company by the Sole Member, by the contribution in kind of claims
4. Amendment of article 5.1 of the articles of incorporation of the Company in order to reflect the planned corporate
capital increase; and
5. Any other business.
176431
L
U X E M B O U R G
<i>First resolutioni>
The Sole Member decided to increase the corporate capital of the Company by an amount of USD 6,544,000.- (six
million five hundred and forty-four thousand US dollars) so as to bring it from its present amount of USD 30,000.- (thirty
thousand US dollars) to the amount of USD 6,574,000.- (six million five hundred and seventy-four thousand US dollars).
<i>Second resolutioni>
The Sole Member decided to issue 6,544.- (six thousand five hundred and forty-four) MRPS with a par value of USD
1,000.- (one thousand US dollars) each, together with the payment of a share premium attached to the MRPS of USD
58,239,725.- (fifty-eight million two hundred and thirty-nine thousand seven hundred and twenty-five US dollars) and the
allocation of the amount of USD 657,400.- (six hundred and fifty-seven thousand four hundred US dollars) to the MRPS
legal reserve of the Company.
<i>Contributor's Intervention - Subscription - Paymenti>
There now appeared Matthieu Groetzinger, acting in his capacity as duly appointed special attorney of the Sole Member
by virtue of a proxy given on October 20, 2014 which will remain attached to the present deed.
The appearing person declared to:
- subscribe for and fully pay 6,544.- (six thousand five hundred and forty-four) MRPS with a par value of USD 1,000.-
(one thousand US dollars) each, for a total amount of USD 6,544,000 (six million five hundred and forty-four US dollars)
- pay a share premium attached to the MRPS amounting to USD 58,239,725.- (fifty-eight million two hundred and
thirty-nine thousand seven hundred and twenty-five US dollars)
- allocate to the MRPS legal reserve of the Company the amount of USD 657,400.- (six hundred and fifty-seven thousand
four hundred US dollars);
by the contribution in kind of claims, in an aggregate amount of USD 65,441,125.- (sixty-five million four hundred and
forty-one thousand one hundred twenty-five US dollars) (the “Claims”).
<i>Description of the contributioni>
The appearing person stated that:
The contribution in kind consisted of the full ownership of the Claims, excluding any real estate for a total amount of
USD 65,441,125.- (sixty-five million four hundred and forty-one thousand one hundred and twenty-five US dollars), these
Claims being valued by the board of managers of the Company at the amount of USD 65,441,125.- (sixty-five million four
hundred and forty-one thousand one hundred and twenty-five US dollars) on the basis of a valuation made by the Sole
Member, owner of the Claims.
<i>Evidence of the contribution's existence and valuei>
Proof of the ownership and the value of the Claims have been given by the management of the company.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the contribution being fully carried out, the Sole
Member decided to amend article 5.1 of the articles of incorporation of the Company to read as follows:
5.1. “The Corporation's corporate capital is set at six million five hundred and seventy-four thousand US dollars (USD
6,574,000.-), represented by two (2) classes of shares as follows: thirty (30) ordinary shares (the “Ordinary Shares”) and
six thousand five hundred and forty-four (6,544.-) mandatory redeemable preferred shares (the “Mandatory Redeemable
Preferred Shares”, and together with the Ordinary Shares shall be referred to as the “Shares” unless otherwise expressly
provided herein), having a par value of one thousand US Dollars (USD 1,000.-) each. The respective rights and obligations
attached to each class of Shares are set forth below. The Ordinary Shares will be issued in registered form and vested
with full voting rights and the Mandatory Redeemable Preferred Shares have no voting rights within the limit of article
7.1 of the articles of incorporation of the Corporation..”
<i>Costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its capital increase have been estimated at about sixty thousand five hundred euros (EUR
6,500.-).
For the purpose of the registration taxes, the appearing party declares that the amount of USD 65,441,125.- (sixty-
five million four hundred and forty-one thousand one hundred and twenty-five US dollars) is valued at EUR 51,296,640,34
(fifty-one million two hundred ninety-six thousand six hundred and forty euros and thirty four cents.).
With no other outstanding points on the agenda, and further requests for discussion not forthcoming, the meeting is
closed. The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above ap-
pearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the French text, the English version shall prevail.
176432
L
U X E M B O U R G
Made in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read and translated into a language known by the person appearing, known to the notary
by his surname, Christian name, civil status and residence, the said person appearing signed together with us, the notary,
the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quatorze, le vingt octobre.
Par devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
A comparu:
3147014 Nova Scotia Company, une société constituée et organisée selon les lois de la province de Nouvelle-Ecosse,
ayant son siège social à Suite 900, 1959 Upper Water Street, Halifax, NS Canada, B3J 3N2, inscrite au Registry of Joint
Stock Companies sous le numéro 3147014, agissant par le biais de sa succursale, KDC Investments, Luxembourg Branch,
ayant son siège social au L-5365 Munsbach, 6C rue Gabriel Lippmann, enregistrée auprès du registre du commerce et
des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 189.756 (l’«Associé Unique»);
dûment représentée par Matthieu Groetzinger, avocat, demeurant professionnellement au L-2132 Luxembourg, 20
avenue Marie-Thérèse, en vertu d’une procuration datée du 20 octobre 2014.
Ladite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire agissant pour le compte de la partie com-
parante et par le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour les besoins de l’enregistrement.
Laquelle partie comparante, agissant ès-qualité, a déclaré et demandé au notaire:
I. d’acter que KDC Investments, Luxembourg Branch est l’Associé Unique de la société à responsabilité limitée KDC
Investments Luxembourg Sàrl, ayant son siège social au L-5365 Munsbach, 6C rue Gabriel Lippmann, enregistrée auprès
du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 189.975, constituée suivant acte reçu par
Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Luxembourg, le 22 août 2014, non encore publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations (la «Société»).
II. d’enregistrer les résolutions suivantes qui ont été prises dans l’intérêt de la Société, conformément à l’agenda ci-
dessous:
<i>Ordre du jouri>
1. Augmentation du capital social de la Société à concurrence d'un montant de USD 6.544.000,- (six millions cinq cent
quarante-quatre mille dollars américains) pour le porter de son montant actuel de USD 30.000,- (trente mille dollars
américains) représenté par 30 (trente) parts sociales ordinaires et 0 (zéro) parts privilégiées obligatoirement rachetables
(les «PPOR») d’une valeur nominale de USD 1.000,- (mille dollars américains) chacune, à un montant de USD 6.574.000,-
(six millions cinq cent soixante-quatorze mille dollars américains) par l’émission de 6.544,- (six mille cinq cent quarante-
quatre) PPOR d’une valeur nominale de USD 1.000,- (mille dollars américains) chacune;
2. Allocation d’un montant de USD 657.400,- (six cent cinquante-sept mille quatre cent dollars américains) à la réserve
légale PPOR de la Société;
3. Souscription et libération de toutes les nouvelles PPOR avec le paiement d’une prime d’émission attachée aux PPOR
de USD 58.239.725,- (cinquante-huit millions deux cent trente-neuf mille sept cent vingt-cinq dollars américains) et allo-
cation d’un montant de USD 657.400,- (six cent cinquante-sept mille quatre cent dollars américains) à la réserve légale
PPOR de la Société par l’Associé Unique, par un apport en nature de droits à recevoir;
4. Modification de l’article 5.1 des statuts de la Société pour refléter l’augmentation du capital social de la Société
planifiée; et
5. Divers.
<i>Première résolutioni>
L’Associé Unique a décidé d'augmenter le capital social à concurrence d’un montant de USD 6.544.000,- (six millions
cinq cent quarante-quatre mille dollars américains pour le porter de son montant actuel de USD 30.000,- (trente mille
dollars américains) à un montant de USD 6.574.000,- (six millions cinq cent soixante-quatorze mille dollars américains).
<i>Deuxième résolutioni>
L’Associé Unique a décidé d’émettre 6.544,- (six mille cinq cent quarante-quatre) PPOR d’une valeur nominale de USD
1.000,- (mille dollars américains) chacune, ensemble avec le paiement d’une prime d’émission attachée aux PPOR de USD
58.239.725,- (cinquante-huit millions deux cent trente-neuf mille sept cent vingt-cinq dollars américains) et l’allocation
d'un montant de USD 657.400,- (six cent cinquante-sept mille quatre cent dollars américains) à la réserve légale PPOR
de la Société.
<i>Intervention de l’apporteur - Souscription - Libérationi>
Est alors intervenu aux présentes Matthieu Groetzinger, agissant en sa qualité de mandataire spécial de l’Associé
Unique, en vertu d’une procuration donnée le 20 octobre 2014 qui restera annexée aux présentes.
176433
L
U X E M B O U R G
La partie comparante a déclaré:
- souscrire et payer en totalité 6.544,- (six mille cinq cent quarante-quatre) PPOR d’une valeur nominale de USD
1.000,- (mille dollars américains) chacune, pour un montant total de USD 6.544.000,- (six millions cinq cent quarante-
quatre mille dollars américains);
- payer une prime d’émission attachée aux PPOR de USD 58.239.725,- (cinquante-huit millions deux cent trente-neuf
mille sept cent vingt-cinq dollars américains);
- allouer à la réserve légale PPOR de la Société le montant de USD 657.400,- (six cent cinquante-sept mille quatre cent
dollars américains);
par l’apport en nature de droits à recevoir d’un montant total de USD 65.441.125,- (soixante-cinq millions quatre cent
quarante et un mille cent vingt-cinq dollars américains) (ci-après les «Droits»).
<i>Description de la contributioni>
La partie comparante a déclaré que:
L’apport en nature a consisté en la pleine propriété des Droits excluant tous droits immobiliers pour un montant total
de USD 65.441.125,- (soixante-cinq millions quatre cent quarante et un mille cent vingt-cinq dollars américains), ces Droits
étant évalués par le conseil de gérance de la Société à un montant de USD 65.441.125,- (soixante-cinq millions quatre
cent quarante et un mille cent vingt-cinq dollars américains) sur la base d’une évaluation émise par l’Associé Unique,
détenteur des Droits.
<i>Preuve de l’existence de l’apporti>
Preuve de la propriété et de la valeur des Droits a été donnée par la gérance de la société.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence des déclarations et des résolutions qui ont précédé, l’apport ayant été accompli, l’Associé Unique a
décidé de modifier l’article 5.1 des statuts de la Société comme suit:
5.1. «Le capital social est fixé à USD 6.574.000,- (six millions cinq cent soixante-quatorze mille dollars américains)
représenté par deux (2) catégories de parts comme suit: 30 (trente) parts ordinaires (les «Parts Ordinaires») et 6.544,-
(six mille cinq cent quarante-quatre) parts privilégiées obligatoirement rachetables (les «Parts Privilégiées Obligatoirement
Rachetables» et ci-après collectivement avec les Parts Ordinaires les «Parts»), ayant toutes une valeur nominale de USD
1.000,- (mille dollars américains) chacune. Les obligations et droits respectifs attachés à chaque catégorie de Parts sont
déterminés ci-dessous. Les Parts Ordinaires sont émises sous la forme nominative et assorties de droits de vote et les
Parts Privilégiées Obligatoirement Rachetables ne sont assorties d’aucun droit de vote dans la limite de l’article 7.1 des
statuts de la Société.»
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de l’augmentation de son capital s'élève à environ six mille cinq cents euros (EUR
6.500,-).
Pour les besoins de l’enregistrement, le comparant déclare que le montant de USD 65.441.125,- (soixante-cinq millions
quatre cent quarante et un mille cent vingt-cinq dollars américains) est évalué à la somme de EUR 51.296.640,34 (cinquante
et un millions deux cent quatre-vingt-seize mille six cent quarante euros et trente-quatre centimes).
Plus rien n'étant à l’ordre du jour et aucune demande supplémentaire de discussion n’ayant lieu, le président lève la
séance.
Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur demande de la partie comparante,
le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même partie comparante et
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Le document ayant été lu et traduit en un langage connu de la partie comparante, connue du notaire par son prénom,
nom, état civil et domicile, ladite partie comparante a signé avec Nous, notaire, le présent acte en original.
Signé: GROETZINGER, ARRENSDORFF.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 24 octobre 2014. Relation: LAC / 2014 / 49741. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.
Luxembourg, le 13 novembre 2014.
Référence de publication: 2014176241/202.
(140201566) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2014.
176434
L
U X E M B O U R G
IRE Hotel II HoldCo 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 37A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 158.137.
In the year two thousand and fourteen, on the twenty-ninth day of September,
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Invesco Real Estate Management S.à r.l., a company incorporated and existing under the laws of Luxembourg having
its registered office at 37A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with R.C.S. Luxembourg under number
B133753 acting in its own name but on behalf of Invesco Real Estate - European Hotel Real Estate Fund II FCP-SIF, a
common fund incorporated under the laws on specialized investment funds (“Sole Shareholder”),
represented by Mister Gianpiero SADDI, private employee, residing professionally in L-1750 Luxembourg, 74, avenue
Victor Hugo, pursuant to a proxy dated 25 September 2014, such proxy signed “ne varietur” by the appearing party and
the undersigned notary will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.
The appearing party, acting in its capacity as Sole Shareholder of IRE Hotel II HoldCo 1 S.à r.l., has requested the
undersigned notary to document the following:
The appearing party is the Sole Shareholder of IRE Hotel II HoldCo 1 S.à r.l., a limited liability company (société à
responsabilité limiteé) incorporated under the law of Luxembourg, having its registered office at 37A, Avenue J.F. Kennedy,
L - 1855 Luxembourg, having a share capital of EUR 2.799.111, incorporated by a deed of the notary Henri HELLINCKX,
residing in Luxembourg, on 20 December 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number
661 on 7 April 2011, and entered in the Register of Commerce and Companies in Luxembourg, Section B, under number
B158137 (the “Company”). The articles of association have been amended for the last time pursuant to a deed of notary
Martine SCHAEFFER, dated 28 December 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
number 756 of 22 March 2012.
The appearing party, represented as above mentioned, recognises that it has been fully informed of the resolutions to
be taken on the basis of the following agenda:
<i>Agendai>
1. To increase the Company's subscribed capital by an amount of one million three hundred thirty-two thousand eight
hundred ninety-three Euro (EUR 1.332.893) and to issue one million three hundred thirty-two thousand eight hundred
ninety-three (1.332.893) new shares, with a par value of one Euro (EUR 1), having the same rights and privileges as those
attached to the existing shares and entitlement to dividends as from the day of the decision of the sole shareholder
resolving on the proposed share capital increase.
2. To accept the subscription of one million three hundred thirty-two thousand eight hundred ninety-three (1.332.893)
shares with a par value of one Euro (EUR 1) by the Sole Shareholder and to accept payment in full of these shares by a
contribution in kind (the “Contribution”),
3. To authorise Mister Gianpiero SADDI, employee of Notary SCHAEFFER to state the abovementioned capital in-
crease before a Luxembourg notary, inter alia to amend the first paragraph of article 5 of the articles of association of
the Company,
4. To authorize Ms Nadja Zimmer or any other employee of Invesco Real Estate Management S.à r.l. and Mister
Gianpiero SADDI or any other employee of Notary SCHAEFFER to record the capital increase in the share register of
the Company and to accomplish any necessary formalities in relation to the Luxembourg Trade and Companies Register
and the Mémorial C, with power to sign any documents, delegate under his own responsibility the present power of
attorney to another representative, consent to the above on behalf of the principal and, in general, do whatever seems
appropriate or useful.
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to increase the Company's subscribed capital by an amount of one million three hundred
thirty-two thousand eight hundred ninety-three Euro (EUR 1.332.893) so as to raise it from its current amount of two
million seven hundred ninety-nine thousand one hundred eleven Euro (EUR 2.799.111) divided into two million seven
hundred ninety-nine thousand one hundred eleven (2.799.111) shares, each share with a par value of one Euro (EUR 1)
to four million one hundred thirty-two thousand four Euro (EUR 4.132.004) divided into four million one hundred thirty-
two thousand four (4.132.004) shares, each share, with a nominal value of one Euro (EUR 1) and to issue one million
three hundred thirty-two thousand eight hundred ninety-three (1.332.893) new shares so as to raise the number of shares
from two million seven hundred ninety-nine thousand one hundred eleven (2.799.111) shares to four million one hundred
thirty-two thousand four (4.132.004) shares, each share with a par value of one Euro (EUR 1), having the same rights and
privileges as those attached to the existing share and entitlement to dividends as from the day of the decision of the Sole
Shareholder resolving on the proposed capital increase.
176435
L
U X E M B O U R G
<i>Subscription and paymenti>
Thereupon appeared Mister Gianpiero SADDI, prenamed his/her capacity as duly authorized attorney in fact of Invesco
Real Estate Management S.à r.l. acting in its own name but on behalf of Invesco Real Estate - European Hotel Real Estate
Fund II FCP-SIF, by virtue of the proxy referred to here above.
The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of the Sole Shareholder for one million three
hundred thirty-two thousand eight hundred ninety-three (1.332.893) new shares so as to raise the number of shares from
two million seven hundred ninety-nine thousand one hundred eleven (2.799.111) shares to four million one hundred
thirty-two thousand four (4.132.004) shares, each share with a par value of one Euro (EUR 1) and to accept payment in
full of each of these shares by the conversion into capital of a claim against IRE Hotel II HoldCo 1 S.à r.l. in the amount
of one million three hundred thirty-two thousand eight hundred ninety-three Euro (EUR 1.332.893) arising from a claim
one million three hundred thirty-two thousand eight hundred ninety-three Euro (EUR 1.332.893) from the Sole Share-
holder towards the Company (the “Contribution in Kind”).
The Sole Shareholder acknowledged the value of the Contribution in Kind as described in the report of the board of
managers of the Company dated 25 September 2014 (which shall be annexed hereto to be registered with the deed).
The Sole Shareholder approved the valuation of the Contribution in Kind.
The Sole Shareholder acting through its duly authorized attorney in fact declared that there exists no impediment to
the free transferability of the Contribution in Kind to the Company without any restriction or limitation and that valid
instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities necessary to perform a valid
transfer of the Contribution in Kind to the Company.
Proof of the existence and the ownership of the Sole Shareholder of the Contribution in Kind have been given to the
undersigned notary.
The Sole Shareholder resolved to allocate an amount equal to the nominal value of the new shares to the share capital
accounts.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend the first paragraph of article 5 of the articles of association of the Company.
The first paragraph of article 5 of the articles of association shall now read as follows:
Art. 5. The issued share capital of the Company is set at four million one hundred thirty-two thousand four Euro (EUR
4.132.004) divided into four million one hundred thirty-two thousand four (4.132.004) shares with a nominal value of one
Euro (EUR 1) each.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to authorize Ms Nadja Zimmer or any other employee of Invesco Real Estate Mana-
gement S.à r.l. and Mister Gianpiero SADDI, employee of Notary SCHAEFERR to record the capital increase in the share
register of the Company and to accomplish any necessary formalities in relation to the Luxembourg Trade and Companies
Register and the Mémorial C with power to sign any documents, delegate under her own responsibility the present power
of attorney to another representative, consent to the above on behalf of the principal and, in general, do whatever seems
appropriate or useful.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this
document, are estimated at approximately two thousand eight hundred Euro (EUR 2,800.-).
The undersigned notary who understands English, states herewith that on request of the above appearing person the
present deed is worded in English followed by a German version, on request of the same person and in case of any
differences between the English and the German text, the English text will prevail.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name, civil
status and residence, the said person signed together with Us, the notary, this original deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangegangenen Texts:
Im Jahre zweitausendvierzehn, am neunundzwanzigsten Tag des Monats September,
Vor der unterzeichnenden Notarin Martine SCHAEFFER, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
IST ERSCHIENEN:
Invesco Real Estate Management S.à r.l., eine nach Luxemburgischen Gesetz gegründete und bestehende Gesellschaft
mit beschränkter Haftung mit Sitz in 37A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, eingetragen im Firmenregister Lu-
xembourg unter der Nummer B 133753, handelnd im Eigenen Namen aber für Rechnung von Invesco Real Estate -
European Hotel Real Estate Fund II FCP-SIF, einem common fund errichtet gemäß der Gesetzte für spezialisierte
176436
L
U X E M B O U R G
Investmentfonds („Alleiniger Gesellschafter“), vertreten durch Herrn Gianpiero SADDI, Privatangestellter, mit Ge-
schäftsadresse in L-1750 Luxemburg, 74, avenue Victor Hugo, durch Vollmacht vom 25. September 2014.
Die Erschienene, die im Namen des alleinigen Gesellschafters der IRE Hotel II HoldCo 1 S.à r.l. handelt, bittet die
Notarin folgendes festzuhalten:
Die erschienene Partei ist der alleinige Gesellschafter der IRE Hotel II HoldCo 1 S.à r.l., eine Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung (société à responsabilité limitée), gegründet nach luxemburgischen Recht, mit Gesellschaftssitz in 37A,
Avenue J.F. Kennedy, L - 1855 Luxemburg, mit einem Gesellschaftskapital in Höhe von EUR 2.799.111, am 20. Dezember
2010 von Notar Henri Hellickx, tätig in Luxembourg, veröffentlicht am 7. April 2011 im Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, unter der Nummer 661 veröffentlicht, und eingetragen im luxemburgischen Handelsund Gesellschafts-
register unter der Nummer B158137 (die „Gesellschaft“). Die Satzung wurde das letzte Mal abgeändert durch Urkunde
der Notarin Martine SCHAEFFER vom 28. Dezember 2011 und veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations unter Nummer 756 am 22. März 2012.
Der Erschienene, vertreten wie oben erwähnt, gibt an, über die folgenden Beschlüsse der Agenda informiert zu sein:
<i>Agendai>
1. Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft um eine Millionen dreihundertzweiunddreißigtausend achthundertd-
reiundneunzig Euro (EUR 1.332.893) durch Ausgabe von eine Millionen dreihundertzweiunddreißigtausend achthun-
dertdreiundneunzig (1.332.893) neuen Anteilen mit einem Nennwert von einem Euro (EUR 1). Die Anteile haben
dieselben Rechte und Privilegien wie die vorherigen Anteile und sind ab dem Tag des Gesellschafterbeschlusses, der über
die Kapitalerhöhung bestimmt, zur Dividende berechtigt.
2. Genehmigung der Zeichnung von eine Millionen dreihundertzweiunddreißigtausend achthundertdreiundneunzig
(1.332.893) Anteilen mit einem Nennwert von einem Euro (EUR 1) durch den Alleinigen Gesellschafter und die Geneh-
migung der Zahlung des Anteils durch Sacheinlage (die „Sacheinlage“).
3. Beauftragung von Herrn Gianpiero SADDI, vorgenannt, Mitarbeiter der Notarin SCHAEFFER diese Kapitalerhöhung
vor der Notarin zu beantragen und somit den ersten Paragraph des Artikel 5 der Statuten der Gesellschaft zu ändern
und
4. Beauftragung von Frau Nadja Zimmer oder jedem anderen Mitarbeiter der Invesco Real Estate Management S.à r.l.
und Herrn Gianpiero SADDI oder jeder andere Mitarbeiter der Notarin SCHAEFFER den Beschluss über die Kapitaler-
höhung im Anteilsregister der Gesellschaft zu dokumentieren, sowie alle notwendigen Formalitäten im Zusammenhang
mit dem luxemburgischen Firmen- und Handelsregister und dem Mémorial C zu veranlassen. Die Vollmacht erstreckt
sich auf die Unterzeichnung aller notwendigen Dokumente. Die Vollmacht kann eigenverantwortlich und im Sinne des
oben genannten an Dritte weitergegeben werden, im Allgemeinen ist die Bevollmächtigte zu jeder Handlung, die ange-
messen und hilfreich ist, bevollmächtigt.
<i>Erster Beschlussi>
Der alleinige Gesellschafter beschließt das Stammkapital der Gesellschaft um eine Millionen dreihundertzweiunddrei-
ßigtausend achthundertdreiundneunzig Euro (EUR 1.332.893) von derzeitigen zwei Millionen siebenhundertneunund-
neunzigtausend einhundertelf Euro (EUR 2.799.111) aufgeteilt in zwei Millionen siebenhundertneunundneunzigtausend
einhundertelf (2.799.111) Anteile, mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1) auf vier Millionen einhundertzwei-
unddreißigtausend vier Euro (EUR 4.132.004) unterteilt in vier Millionen einhundertzweiunddreißigtausend vier
(4.132.004) Anteile mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1) zu erhöhen. Es werden eine Millionen dreihundert-
zweiunddreißigtausend achthundertdreiundneunzig (1.332.893) neue Anteile ausgegeben, was die derzeitige Anzahl der
Anteile von zwei Millionen siebenhundertneunundneunzigtausend einhundertelf (2.799.111) auf vier Millionen einhun-
dertzweiunddreißigtausend vier (4.132.004) Anteile mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1) erhöht. Die Anteile
haben dieselben Rechte und Privilegien wie die vorherigen Anteile und sind zur Dividende berechtigt ab dem Tag des
Gesellschafterbeschlusses der über die Kapitalerhöhung bestimmt.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Hier erschien Herrn Gianpiero SADDI, vorgenannt, mit Geschäftssitz in Luxembourg, in ihrer Funktion als Bevoll-
mächtigte der Invesco Real Estate Management S.à r.l. handelnd im Eigenen Namen aber für Rechnung von Invesco Real
Estate - European Hotel Real Estate Fund II FCP-SIF bevollmächtigt wie oben beschrieben.
Die Erschienene gibt an im Namen und im Auftrag des Alleinigen Gesellschafter für eine Millionen dreihundertzwei-
unddreißigtausend achthundertdreiundneunzig (1.332.893) neue Anteile zu zeichnen, um die Anzahl der Anteile von zwei
Millionen siebenhundertneunundneunzigtausend einhundertelf (2.799.111) auf vier Millionen einhundertzweiunddreißig-
tausend vier (4.132.004) Anteile mit einem Nennwert von einem Euro (EUR 1) zu erhöhen. Die Zahlung der Anteile
erfolgt durch Umwandlung eines Anspruches gegen die IRE Hotel II HoldCo 1 S.à r.l. auf Zahlung in Höhe von eine
Millionen dreihundertzweiunddreißigtausend achthundertdreiundneunzig Euro (EUR 1.332.893), in Gesellschaftskapital.
(die „Sachkapitalerhöhung“). Der Anspruch ergibt sich aus einer Forderung des alleinigen Gesellschafters in Höhe von
eine Millionen dreihundertzweiunddreißigtausend achthundertdreiundneunzig Euro (EUR 1.332.893) gegen die Gesell-
schaft.
176437
L
U X E M B O U R G
Der alleinige Gesellschafter nimmt den Wert der Sacheinlage, wie im Geschäftsführerreport vom 25. September 2014
beschrieben, zur Kenntnis (der Report soll als Anhang, zusammen mit der Urkunde einregistriert werden). Der Alleinige
Gesellschafter genehmigt die Bewertung der Sacheinlage.
Der Alleinige Gesellschaftererklärt, dass es keine Einschränkung hinsichtlich der freien Übertragbarkeit des Sachkapitals
an die Gesellschaft besteht. Klare Anweisung zur Anmeldung, Registrierung und anderen notwendigen Formalitäten, um
die Sachkapitalerhöhung durchzuführen, wurden erteilt.
Dem Notar wurde bestätigt, dass das Sachkapital besteht und im Besitz des Alleinigen Gesellschafters ist.
Der Alleinige Gesellschafter beschließt, einen Betrag in Höhe des Nennwerts der neuen Anteile dem Gesellschafts-
kapital zuzuführen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Der alleinige Gesellschafter beschließt den ersten Paragraph des 5. Artikels der Satzung der Gesellschaft zu ändern.
Der erste Paragraph des 5. Artikels der Satzung soll wie folgt lauten:
Art. 5. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt vier Millionen einhundertzweiunddreißigtausend vier Euro (EUR
4.132.004) geteilt in vier Millionen einhundertzweiunddreißigtausend vier (4.132.004) Anteile mit einem Nennwert von
je einem Euro (EUR 1).
<i>Dritter Beschlussi>
Der Alleinige Gesellschafter hat beschlossen Frau Nadja Zimmer oder jeden Mitarbeiter der Invesco Real Estate Ma-
nagement S.à r.l. und Herrn Gianpiero SADDI oder jeder andere Mitarbeiter der Notarin SCHAEFFER zu bevollmächtigen
die Kapitalerhöhung im Anteilsregister der Gesellschaft zu dokumentieren, sowie alle notwendigen Formalitäten im Zu-
sammenhang mit dem luxemburgischen Firmen- und Handelsregister und dem Mémorial C zu veranlassen. Die Vollmacht
erstreckt sich auf die Unterzeichnung aller notwendigen Dokumente. Die Vollmacht kann eigenverantwortlich und im
Sinne des oben genannten an Dritte weitergegeben werden, im Allgemeinen ist die Bevollmächtigte zu jeder Handlung,
die angemessen und hilfreich ist, bevollmächtigt.
<i>Kosteni>
Sämtlich Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Gebühren, welche der Gesellschaft erwachsen, werden auf zweitausen-
dachthunder Euro (EUR 2.800.-) geschätzt.
Die unterzeichnende Notarin, die die englische Sprache spricht und versteht, erklärt hiermit, dass die vorliegende
Urkunde in englischer Sprache ausgefertigt wird, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, auf Antrag der erschienenen
Person und im Fall von Abweichungen zwischen dem englischen und deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.
Die vorliegende notarielle Urkunde wurde in Luxembourg ausgestellt, an dem zu Beginn des Dokumentes aufgeführten
Tag.
Nachdem das Dokument der erschienen Person vorgelegt wurde, hat die Bevollmächtigte das vorliegende Protokoll
zusammen mit der Notarin unterzeichnet.
Signé: G. Saddi et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 2 octobre 2014. Relation: LAC/2014/46003. Reçu soixante-quinze euros Eur
75.-
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de
Commerce.
Luxembourg, le 13 novembre 2014.
Référence de publication: 2014176211/210.
(140202149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2014.
JC. Partner, Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 143-147, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 82.513.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour JC PARTNER S.A.
i>FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN S.A R.L.
Référence de publication: 2014176225/11.
(140201369) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2014.
176438
L
U X E M B O U R G
Le Midofa S.C.I., Société Civile Immobilière.
Siège social: L-1716 Luxembourg, 30, rue Joseph Hansen.
R.C.S. Luxembourg E 5.489.
STATUTS
L'an deux mil quatorze, le vingt-sept octobre.
Par-devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
ONT COMPARU:
1) Madame Jeanne Alice SCHREINER, née le 14 avril 1947 à Luxembourg, retraitée, domiciliée au 30, rue Joseph
Hansen, L-1716 Luxembourg,
2) Monsieur Henri Bernard GRISIUS, né le 1
er
juin 1944 à Diekirch, retraité, domicilié au 30, rue Joseph Hansen,
L-1716 Luxembourg.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société civile qu'ils entendent constituer entre eux.
Titre I
er
. - Dénomination - Objet - Siège
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société civile immobilière qui prendra la dénomination «LE MIDOFA
S.C.I.».
Art. 2. La société a pour objet, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l’étranger, l’acquisition, la vente, la cons-
truction, l’aménagement, l’administration, l’exploitation, la mise en valeur, la mise en location, ainsi que la gestion d’un ou
de plusieurs immeubles pour son propre compte.
La société pourra dans le cadre de son activité accorder notamment hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou
se porter caution réelle d’engagement en faveur de tiers.
D’une façon générale, la société pourra effectuer toutes autres activités nécessaires ou utiles, susceptibles de favoriser
soit directement, soit indirectement, la réalisation de cet objet, pourvu qu’elles ne soient pas à caractère commercial ou
susceptibles de porter atteinte au caractère exclusivement civil de l’activité sociale.
Art. 3. Le siège social est dans la commune de Luxembourg.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés,
réunis en assemblée générale.
Titre II. - Capital social - Parts d'intérêts
Art. 4. Le capital social est fixé à dix mille euros (EUR 10.000,-).
Il est représenté par dix (10) parts d'intérêts sans désignation de valeur nominale.
Art. 5. Les copropriétaires indivis d'une ou de plusieurs parts sont tenus, pour l’exercice de leurs droits, de se faire
représenter auprès de la société par un seul d'entre eux ou par un mandataire commun. Ce dernier devra être agréé par
décision des associés prise à la majorité des deux/tiers (2/3) du capital existant.
Le même agrément est requis pour les représentants des mineurs, administrateurs légaux ou tuteurs. En cas de refus,
il y aura lieu à nomination d'un administrateur ou tuteur ad hoc, agréé préalablement. Jusqu'à ces désignations la société
peut suspendre l’exercice des droits afférents.
Titre III. - Durée - Dénonciation
Art. 6. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 7. Tout associé pourra dénoncer sa participation dans la société par lettre recommandée envoyée aux associés
et aux gérants avec un préavis de six mois. L'associé désireux de sortir de la société suivra les dispositions de l’article dix
des statuts.
Au cas où aucun associé ou tiers agréé n'est disposé à acquérir les parts au prix fixé, l’associé désireux de sortir de la
société pourra en demander la dissolution et la liquidation.
Titre IV. - Transmissions et cessions de parts
Art. 8. Transmission pour cause de mort. Les parts sont librement transmissibles pour cause de mort, même par
dispositions de dernière volonté, mais exclusivement en ligne directe et au conjoint.
Tout autre bénéficiaire en cas de transmission pour cause de mort devra être agréé par une décision prise à la majorité
de plus de 2/3 du capital social appartenant aux associés survivants. En cas de refus le bénéficiaire devra procéder con-
formément à l’article 9 des statuts, à l’exclusion de l’alinéa D), et sera lié par le résultat de l’expertise. En cas de refus
d'achat, le bénéficiaire sera associé de plein droit.
Pour tout autre héritier les dispositions de l’article 10 des statuts sont à suivre.
176439
L
U X E M B O U R G
Art. 9. Cessions entre vifs.
A) Si un associé se propose de céder entre vifs tout ou partie de ses parts sociales, il doit les offrir à ses coassociés
proportionnellement à leur participation dans la société. Néanmoins, les parts sont librement cessibles aux descendants
en ligne directe.
Par cession entre vifs au sens du présent article, on entend toute cession entre vifs, à titre onéreux ou gratuit, par
apport en société, fusion, scission ou dissolution de société, et par apport en un régime matrimonial de communauté.
B) En cas de désaccord persistant des associés sur le prix après un délai de un mois, le ou les associés qui entendent
céder les parts et le ou les associés qui se proposent de les acquérir, chargeront de part et d’autre un expert pour établir
la valeur de cession, en se basant sur la valeur vénale des parts.
En cas de désaccord, ces experts s’en adjoindront un troisième pour les départager.
En cas de refus de l’une des parties de désigner son expert ou à défaut de la nomination d’un expert dans les 15 jours
de la sommation qui lui aura été faite à cet effet par lettre recommandée par l’autre partie, la nomination du troisième
expert sera faite par le Président du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, sur requête de la partie la plus diligente.
L’établissement de la valeur de cession devra se faire endéans un mois de la désignation du dernier expert.
C) La société communique par lettre recommandée le résultat de l’expertise à tous les associés, en les invitant à faire
savoir dans un délai de deux semaines, s’ils sont disposés à acheter ou céder les parts au prix établi. Si plusieurs associés
déclarent vouloir acquérir les parts proposées à la vente, elles seront offertes à ces associés en proportion de leur
participation dans la société.
Les associés restant dans la société peuvent faire acquérir les parts dont aucun associé n’aura voulu par un tiers agréé
entre eux à la majorité du capital détenu par eux.
Le silence des associés pendant le prédit délai de deux semaines équivaut à un refus.
D) Dans ce cas, l’associé qui entend céder ses parts peut les offrir à des non-associés, étant entendu qu’un droit de
préemption est encore réservé aux autres associés ou au tiers par eux agréé en proportion de leurs participations pendant
un délai d’un mois à partir de la date de la communication par lettre recommandée de l’accord avec les non-associés et
suivant les conditions d’un tel accord.
E) Les parts ne peuvent être mises en gage que de l’accord unanime des associés.
Art. 10. Dans tous les autres cas les parts ne pourront être cédées qu'en respectant les dispositions de l’article 189
de la loi sur les sociétés.
Art. 11. Les cessions de parts s'opéreront conformément à l’article 1690 du Code civil, et seront publiées conformé-
ment à l’article 11 bis, paragraphe 2, point 3 de la loi du 10 août 1915.
Titre V. - Administration et surveillance
Art. 12. La société est gérée par un ou plusieurs associés-gérants, nommés et révoqués ad nutum par les associés
décidant à la majorité des voix présentes ou représentées.
L'assemblée fixe leur nombre et la durée de leur mandat.
La société est engagée par la signature individuelle de chacun des gérants.
Art. 13. Les associés-gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et faire ou
autoriser tous les actes, actions et opérations rentrant dans son objet, à l’exception des actes de disposition réservés à
l’assemblée générale des associés et dont il est question au dernier alinéa du présent article.
Ils administrent les biens de la société et ils la représentent vis-à-vis des tiers et de toutes administrations. Ils consentent,
acceptent et résilient tous baux et locations, pour le temps et au prix, charges et conditions qu'ils jugent convenables; ils
touchent les sommes dues à la société à quelque titre et pour quelque cause que ce soit; ils payent toutes celles qu'elle
peut devoir ou en ordonnent le paiement. Ils règlent et arrêtent tous comptes avec tous créanciers et débiteurs. Ils
exercent toutes les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant.
Ils autorisent et signent toutes subrogations, postpositions et toutes mainlevées d'inscriptions, saisies, oppositions,
privilèges et autres droits avant ou après paiement.
Ils arrêtent les états de situation et les comptes qui doivent être soumis à l’assemblée générale des associés; ils statuent
sur toutes propositions à lui faire et arrêtent l’ordre du jour.
Ils peuvent conférer à telles personnes que bon leur semble des pouvoirs pour un ou plusieurs objets déterminés.
La présente énumération est énonciative et non limitative.
L'assemblée des associés a la compétence exclusive pour décider de tous actes de disposition des actifs immobiliers
de la société, tel que vente, achat, échange, lotissement, remembrement, constitution d'hypothèques.
Elle décidera alors à la majorité du capital social.
Art. 14. Dans leurs rapports respectifs avec leurs co-associés, les associés seront tenus des dettes et des engagements
de la société, chacun dans la proportion du nombre de parts lui appartenant.
176440
L
U X E M B O U R G
Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés seront tenus des dettes et des engagements sociaux conformément
à l’article 1863 du Code civil, mais seulement en proportion des parts détenues dans la société.
Dans tous les actes qui contiendront des engagements au nom de la société, et qui ne portent pas la signature de tous
les associés, les gérants ou mandataires spéciaux de la société devront, sous leur responsabilité, obtenir des créanciers
une renonciation formelle au droit d'exercer une action personnelle contre les associés, de telle sorte que lesdits créan-
ciers ne puissent, par suite de cette renonciation, intenter d'actions et de poursuites que contre la société et exclusivement
sur les biens qui lui appartiennent.
Art. 15. Chacun des associés a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la société.
Titre VI. - Assemblées
Art. 16. Les associés se réunissent en assemblée aussi souvent que les intérêts de la société l’exigent, et au moins une
fois l’an pour approuver les comptes sociaux.
Le droit de convocation appartient à chaque gérant et à chaque associé détenant au moins un cinquième du capital.
Les convocations ont lieu au moyen de lettres recommandées adressées aux associés au moins huit jours francs à
l’avance et qui doivent indiquer sommairement l’ordre du jour.
Les associés peuvent même se réunir sur convocation verbale et sans délai si tous les associés sont présents ou
représentés. De leur accord unanime, les décisions peuvent être prises par voie circulaire.
Art. 17. Toute assemblée n'est valablement constituée que si elle réunit un quorum de présence de deux/tiers du
capital existant.
Toutes décisions, même celles modificatives des statuts, sauf celles prévues à l’article 12, ne sont valablement prises
qu'à la majorité du capital social.
Les assemblées sont présidées par l’associé détenant le plus grand nombre de parts, en y comptant les parts en usufruit.
En cas de démembrement de la propriété des parts d’intérêt entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, le droit de vote
aux assemblées appartient à l’usufruitier.
Titre VII. - Dissolution - Réduction de capital
Art. 18. En cas de dissolution de la société, la liquidation de la société se fera par les soins du ou des associés-gérants
ou de tout autre liquidateur qui sera nommé et dont les attributions seront déterminées par les associés.
Art. 20. La société ne sera pas dissoute par le décès d'un ou de plusieurs des associés.
De même l’interdiction, la déconfiture, la faillite ou la liquidation judiciaire d'un ou de plusieurs des associés ne mettront
point fin à la société; celle-ci continuera entre les autres associés, à l’exclusion de l’associé ou des associés en état
d'interdiction, de déconfiture, de faillite ou de liquidation judiciaire lesquels ne pourront prétendre qu'au payement de la
valeur de leurs parts fixée conformément aux dispositions de l’article 189 de la loi sur les sociétés, qui s'impose donc
notamment en cas de faillite ou de déconfiture.
Les héritiers et légataires de parts soumis à agrément ou non, ou les créanciers d'un associé ne peuvent sous aucun
prétexte, pendant la durée de la société et jusqu'à la clôture de sa liquidation, requérir l’apposition de scellés sur les biens,
documents et valeurs de la société ou en requérir l’inventaire, ni en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer
en aucune manière dans l’administration de la société et doivent pour l’exercice de leurs droits, s'en rapporter aux
inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.
Art. 21. En cas de dissolution ou de réduction de capital par remboursement, l’usufruit de parts est capitalisé en tenant
compte de l’expectative de vie de l’usufruitier calculée d'après des tables de mortalité récentes et sur base d'un taux de
rendement égal à la moyenne des emprunts obligataires à 3 ans émis en euros sur la Place de Luxembourg au cours des
trois mois ayant précédé le mois du calcul.
Art. 22. Les modifications des présents statuts peuvent se faire par actes sous seing privé, à publier par extraits dans
les cas prescrits par les articles 8 et 11 bis de la loi 10 août 1915.
Titre VIII. - Dispositions générales
Art. 23. Les articles 1832 et 1872 du Code Civil trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les
présents statuts.
<i>Souscription et libération du capitali>
Ensuite les comparants ont requis le notaire instrumentaire d'acter qu'ils souscrivent les dix (10) parts comme suit:
1. Madame Jeanne Alice SCHREINER, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cinq (5)
2. Monsieur Henri Bernard GRISIUS, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cinq (5)
TOTAL: parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dix (10)
Ces parts d'intérêts ont été intégralement libérées par les associés par des versements en espèces d'un montant de
cinq mille euros (EUR 5.000,-) chacun.
176441
L
U X E M B O U R G
Par suite des versements effectués, le montant de dix mille euros (EUR 10.000,-) se trouve dès-à-présent à la libre
disposition de la société.
Les associés se donnent mutuellement quittance et décharge.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élève à environ EUR 900,-.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les associés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée et à l’unanimité des
voix, ils ont pris les résolutions suivantes:
1. La société est gérée et administrée par 2 associés-gérants.
2. Sont nommés associés-gérants pour une durée indéterminée,
1) Madame Jeanne Alice SCHREINER, née le 14 avril 1947 à Luxembourg, retraitée, domiciliée au 30, rue Joseph
Hansen, L-1716 Luxembourg,
2) Monsieur Henri Bernard GRISIUS, né le 1
er
juin 1944 à Diekirch, retraité, domicilié au 30, rue Joseph Hansen,
L-1716 Luxembourg.
Ils engageront la société par leur signature individuelle.
3. L'adresse de la société est fixée au 30, rue Joseph Hansen, L-1716 Luxembourg.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation données par le notaire instrumentant aux comparants, tous connus du notaire par
noms, prénoms, états et demeures, ils ont tous signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. SCHREINER, H. GRISIUS, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 30 octobre 2014. Relation: LAC/2014/50656. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): I. THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 07 novembre 2014.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2014173847/187.
(140198377) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.
Fondation Sociale Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1259 Senningerberg, 13-15, Breedewues.
R.C.S. Luxembourg B 39.658.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire des actionnaires de la société Fondation Sociale Holding S.A. en liquidationi>
<i>volontaire qui s'est tenue à Luxembourg en date du 12 novembre 2014.i>
L'Assemblée a:
- Prononcé la clôture de la liquidation de la société anonyme Fondation Sociale Holding S.A., ayant son siège social à
13-15, Breedewues - L-1259 Senningerberg, constituée suivant acte notarié, en date du 6 février 1992, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C numéro 342 du 8 août 1992 et mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire
Jean Seckler suivant acte du 23 novembre 2001.
- Décidé que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans à partir du
12 novembre 2014, à l'adresse de la société Fiduciaire Scheiwen Nickels & Associés S.à r.l. à L-1259 Senningerberg, 13-15,
Breedewues.
Senningerberg, le 12 novembre 2014.
<i>Pour la société
Mandatairei>
Référence de publication: 2014176106/21.
(140202127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2014.
176442
L
U X E M B O U R G
Erlo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5450 Stadtbredimus, 1B, Wäistrooss.
R.C.S. Luxembourg B 84.725.
<i>Auszug der Beschlüsse der Ausserordentlichen Generalversammlung vom 31. Oktober 2014i>
Im Jahre 2014, am 31.Oktober haben die Aktionäre der ERLO S.A. in einer ausserordentlichen Generalversammlung
folgende Beschlüsse angenommen:
Aufgrund des Ablebens des Verwaltungsratmitglieds, Herrn Heinrich LOHMEIER am 29/09/2014, wurde beschlossen:
- Herrn Christoph LOHMEIER, geboren am 05/11/1994 in Schkeuditz (D), wohnhaft in D-04129 Leipzig, Wittenberger
Strasse 19,
für fünf Jahre zum neuen Verwaltungsratmitglied zu ernennen, das heisst bis zur ordentlichen Generalversammlung
des Jahres 2016.
Luxemburg, den 31. Oktober 2014.
Référence de publication: 2014174529/16.
(140200289) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2014.
MONTECARO S.A., société de gestion de patrimoine familial, "SPF", Société Anonyme - Société de
Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 44.266.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>11 décembre 2014i> à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2013, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31
décembre 2013.
4. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2014185304/1023/17.
NRG 6 S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 165.949.
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Qui se tiendra au siège social, en date du <i>12 décembre 2014i> à 14 heures, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Discussion et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2012 et au 31 décembre 2013 et des
comptes de résultats.
2. Discussion et approbation des rapports du Commissaire 2012 et 2013.
3. Octroi de la décharge, telle que requise par la loi, aux Administrateurs et au Commissaire pour les fonctions
exercées par ceux-ci dans la société durant l'exercice social qui s'est terminé le 31 décembre 2012, ainsi que pour
l'exercice social qui s'est terminé le 31 décembre 2013.
4. Décision de l'affectation du résultat réalisé au cours des exercices précités.
5. Le cas échéant, décision conformément à l'article 100 des LCSC.
6. Modification au sein du Conseil d'administration et renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
7. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2014185305/1004/21.
176443
L
U X E M B O U R G
Climmolux Holding, Société Anonyme.
Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.
R.C.S. Luxembourg B 182.191.
<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration tenu le 24 octobre 2014 au siège sociali>
<i>Résolutionsi>
Les membres du Conseil d'Administration décident de transférer le siège social du 5 Avenue Gaston Diderich, L-1420
Luxembourg au 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
AFC Benelux Sàrl
Signature
Référence de publication: 2014176756/14.
(140202362) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2014.
Pub.K Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1326 Luxembourg, 32, rue Auguste Charles.
R.C.S. Luxembourg B 60.496.
Les actionnaires sont priés d'assister à
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de la société qui se tiendra extraordinairement le <i>vendredi 12 décembre 2014i> à 16.00 hrs au siège de la société à
Luxembourg, 32, Rue Auguste Charles, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et discussion des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sur l'exercice
clôturé au 31 décembre 2013;
2. Présentation et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2013;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge à donner aux organes de la société;
5. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2014184599/561/18.
AXA L Fund, AXA Luxembourg Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 27.225.
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
des actionnaires de AXA L FUND, SICAV se tiendra au siège de BGL BNP Paribas, 50, avenue J.F. Kennedy à Luxem-
bourg, le <i>vendredi 12 décembre 2014i> à 15.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du conseil d'administration sur l'exercice clos le 30 septembre 2014.
2. Rapport du réviseur d'entreprises agréé.
3. Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2014.
4. Dividende des actions de distribution.
5. Décharge aux administrateurs.
6. Divers.
Pour pouvoir assister à l'assemblée générale annuelle, conformément à l'article 11 des statuts, les propriétaires d'ac-
tions au porteur doivent avoir déposé leurs actions cinq jours au moins avant l'assemblée annuelle au siège social, auprès
de BGL BNP Paribas, ou auprès de AXA Bank Europe S.A., Bruxelles.
Les résolutions à l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle ne requièrent pas de quorum spécial et seront
adoptées si elles sont votées à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2014184601/755/22.
176444
L
U X E M B O U R G
Inspiration & Information Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7243 Bereldange, 83, rue du Dix Octobre.
R.C.S. Luxembourg B 160.110.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014172957/9.
(140197590) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2014.
Energie 5 Holding S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 53.516.
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Qui se tiendra au siège social, en date du <i>12 décembre 2014i> à 15 heures, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Discussion et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2012 et au 31 décembre 2013 et des
comptes de résultats.
2. Discussion et approbation des rapports du Commissaire 2012 et 2013.
3. Octroi de la décharge, telle que requise par la loi, aux Administrateurs et au Commissaire pour les fonctions
exercées par ceux-ci dans la société durant l'exercice social qui s'est terminé le 31 décembre 2012, ainsi que pour
l'exercice social qui s'est terminé le 31 décembre 2013.
4. Décision de l'affectation du résultat réalisé au cours des exercices précités.
5. Le cas échéant, décision conformément à l'article 100 des LCSC.
6. Modification au sein du Conseil d'administration et renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
7. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2014185300/1004/21.
Immobilière Saint Marcel S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 99.814.
Les actionnaires de la société sont convoqués en
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
<i>le lundi 15 décembre 2014i> à 11H00 au siège social de la société afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation du rapport du conseil d'administration, du rapport du commissaire aux comptes et délibération avec
approbation sur les comptes annuels et des rapports de l'année 2013.
2. Affectation du résultat de l'exercice 2013.
3. Décharges à accorder aux membres du conseil d'administration et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
Un projet de texte des résolutions, ainsi que le rapport du conseil d'administration est joint au courrier de convocation
envoyé par voie postale.
En cas d'empêchement, veuillez vous faire représenter par la personne de votre choix. La personne qui vous représente
devra obligatoirement présenter une procuration valable de votre part, à laquelle vous annexerez une copie des titres
que vous detenez dans le capital de la société, ainsi que votre pièce d'identité et celle de votre mandataire. A défaut de
présentation de ces documents, la participation à l'assemblée générale ne sera pas possible.
Olivier BONET-MAURY
Administrateur
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2014178977/24.
176445
L
U X E M B O U R G
KÖHL Aktiengesellschaft, Société Anonyme.
Siège social: L-6868 Wecker, 17, Am Scheerleck.
R.C.S. Luxembourg B 43.668.
Les comptes annuels au 31.03.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014177746/9.
(140203483) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2014.
Ulrika S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 79.219.
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
de ULRIKA S.A., SPF Société Anonyme Société de Gestion de Patrimoine Familial (" SPF ") 1 rue Joseph Hackin
LUXEMBOURG R.C.S de Luxembourg B 79.219 qui se tiendra le <i>lundi 15 décembre 2014i> à 10.00 heures au siège social
avec pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2013 et affectation des résultats,
3. Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
4. Décision à prendre quant à la poursuite de l'activité de la société,
5. Nominations statutaires,
6. Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2014184604/755/21.
AXA Investplus, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 26.830.
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
des actionnaires de AXA INVESTPLUS, SICAV se tiendra au siège de BGL BNP Paribas, 50, avenue J.F. Kennedy à
Luxembourg, le <i>vendredi 12 décembre 2014i> à 16.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du conseil d'administration sur l'exercice clos le 30 septembre 2014.
2. Rapport du Réviseur d'entreprises agréé.
3. Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2014.
4. Dividende des actions de distribution.
5. Décharge aux administrateurs.
6. Nominations statutaires.
7. Réélection du Réviseur d'entreprises agréé.
8. Divers.
Pour pouvoir assister à l'assemblée générale annuelle, conformément à l'article 11 des statuts, les propriétaires d'ac-
tions au porteur doivent avoir déposé leurs actions cinq jours au moins avant l'assemblée annuelle au siège social, auprès
de BGL BNP Paribas, ou auprès de AXA Bank Europe S.A., Bruxelles.
Les résolutions à l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle ne requièrent pas de quorum spécial et seront
adoptées si elles sont votées à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2014184602/755/24.
176446
L
U X E M B O U R G
Locomotive Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 71.077.
Il résulte des actes de la Société que Mr Andrea CARINI et Monsieur Antonio Forte ont présenté leur démission de
leur fonction d'administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Citco C&T Luxembourg S.A.
<i>Agent domiciliatairei>
Référence de publication: 2014173039/12.
(140197738) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2014.
NRG 7 S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 175.696.
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Qui se tiendra au siège social, en date du <i>12 décembre 2014i> à 16 heures, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Discussion et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2012 et au 31 décembre 2013 et des
comptes de résultats.
2. Discussion et approbation des rapports du Commissaire 2012 et 2013.
3. Octroi de la décharge, telle que requise par la loi, aux Administrateurs et au Commissaire pour les fonctions
exercées par ceux-ci dans la société durant l'exercice social qui s'est terminé le 31 décembre 2012, ainsi que pour
l'exercice social qui s'est terminé le 31 décembre 2013.
4. Décision de l'affectation du résultat réalisé au cours des exercices précités.
5. Le cas échéant, décision conformément à l'article 100 des LCSC.
6. Modification au sein du Conseil d'administration et renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
7. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2014185302/21.
Mine Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 76.332.
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Qui se tiendra au siège social, en date du <i>12 décembre 2014i> à 17 heures, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Discussion et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2012 et au 31 décembre 2013 et des
comptes de résultats.
2. Discussion et approbation des rapports du Commissaire 2012 et 2013.
3. Octroi de la décharge, telle que requise par la loi, aux Administrateurs et au Commissaire pour les fonctions
exercées par ceux-ci dans la société durant l'exercice social qui s'est terminé le 31 décembre 2012, ainsi que pour
l'exercice social qui s'est terminé le 31 décembre 2013.
4. Décision de l'affectation du résultat réalisé au cours des exercices précités.
5. Le cas échéant, décision conformément à l'article 100 des LCSC.
6. Modification au sein du Conseil d'administration et renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
7. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2014185299/1004/21.
176447
L
U X E M B O U R G
Motorola Solutions Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 30.856,00.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 171.997.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions de l'associé unique de la Société prises en date du 11 novembre 2014 que Mme Sabrina
Colantonio, née à Thionville (France) le 13 mars 1982, ayant son adresse professionnelle au 412F, route d'Esch, L-2086
Luxembourg et M. Abdoulie Jallow né à Fajara (Gambie) le 12 février 1975, de nationalité britannique, ayant son adresse
professionnelle au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg ont été nommés gérants B de la Société avec effet au 11
novembre 2014 pour une durée indéterminée, en remplacement de Mme Laëtitia Jolivalt et Mme Sévérine Lambert,
gérants B démissionnaires.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 novembre 2014.
<i>Pour Motorola Solutions Holding S.à r.l.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2014177022/19.
(140202966) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2014.
Fame International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.
R.C.S. Luxembourg B 129.738.
We hereby give you notice of the
ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders of the Company that will be held extraordinarily on <i>Friday 12th December 2014i> at 10:00 o'clock (local
time) at the following address : Hôtel Sofitel Luxembourg 4, rue du Fort Niedergrunewald Quartier Européen Nord
L-2015 Luxembourg at which the following Agenda will be considered:
<i>Agenda:i>
1. Acknowledgment and acceptance of the proposal of the Executive Board of the Company to hold the annual general
meeting of the Shareholders in respect of the financial year ended on June 30, 2014 on a date which is different
than the date provided for in the Company's Articles, and discharge (quitus) to the Company's Executive Board in
respect thereof.
2. Presentation and approval of the reports of the Executive Board, the Founding Board, the Statutory Auditor and
the Independent Auditor.
3. Approval of the balance sheet and the profit and loss accounts as at June 30, 2014.
4. Approval of the audited consolidated financial statements as at June 30, 2014.
5. Discharge to the Executive Board, the Founding Board, the Statutory Auditor and the Independent Auditor for the
exercise of their mandates up to June 30, 2014.
6. Acceptance of the resignation of two members of the Executive Board and decision to keep these seats temporarily
vacant in view of a co-optation of new members or decision to reduce the number of members of such board from
6 to 4.
7. Re-election of the Statutory Auditor, Mr Marco RIES, for a new term of one year.
8. Re-election of the Independent Auditor, PricewaterhouseCoopers, for the establishment of the consolidated ac-
counts for a new term of one year and change of auditor address.
9. Miscellaneous.
Proxy forms for shareholders not attending the meeting in person as well as voting forms are available at the registered
office of the Company.
To be valid, voting forms must be received by the Company 48 hours before the meeting.
<i>The Executive Boardi>
Référence de publication: 2014183347/33.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
176448
A fleur de peau, S.à r.l.
Auto Team s.à.r.l.
AXA Investplus
AXA Luxembourg Fund
Blue Eagle Portfolios
Carnegie Wealth Management Fund Sicav
CIEI
C & I Latam S.à r.l.
Climmolux Holding
DHC Luxembourg V S.à r.l.
DRC2 S.A.
Eficar
Energie 5 Holding S.A.
Equipements, Fluides et Gaz-Technologies Appliquées S.à r.l.
Erlo S.A.
EuroCore Property 3 S.à r.l.
Europalux Holding S.A.
Evong S.A.
Fame International S.A.
Fincorp Participations S.A.
Fondation Sociale Holding S.A.
Hamada SA
Immobilière Saint Marcel S.A.
Immo Teb SA
Inspiration & Information Sàrl
IRE Hotel II HoldCo 1 S.à r.l.
JC. Partner
Kaiser Investments Holdings S.à r.l.
KDC Investments Luxembourg Sàrl
KÖHL Aktiengesellschaft
LBLux SICAV-FIS
Le Midofa S.C.I.
Locomotive Holding S.A.
Marie Property S.A.
Mendocino S.A.
Mine Holding S.A.
MONTECARO S.A., société de gestion de patrimoine familial, "SPF"
Motorola Solutions Holding S.à r.l.
NRG 6 S.A. SPF
NRG 7 S.A. SPF
Opportunity Umbrella Fund
PIM S.à.r.l.
Primva S.à r.l.
Pub.K Investments S.A.
Recar-Int
REIM EuroCore 1 S.C.A.
Roof Garden S.A.
Sheridan Solutions SICAV-FIS
Swiss Alpha, SICAV
Timberland, SICAV
Ulrika S.A., SPF
Woodimmo S.A.