logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 3665

2 décembre 2014

SOMMAIRE

8F Leasing S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

175920

ArcelorMittal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

175874

ArcelorMittal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

175874

Bravida HoldCo S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

175886

CC Global Investments Master Fund . . . . .

175883

Ceasar International S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . .

175874

Centre Chretien-Social du Sud  . . . . . . . . . .

175874

H'Corp  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

175899

Iceberg International S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

175882

Iena Participations S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

175877

Immo-Ardennes s.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

175877

Incentive Travel International S.à r.l.  . . . .

175877

Inteclux Software Engineering S.A.  . . . . . .

175877

Intercontinental Group for Commerce In-

dustry and Finance S.A., SPF . . . . . . . . . . .

175876

International Brands Promotion S.A.  . . . .

175882

International Equity Investors S.A.  . . . . . .

175879

International Fair Consulting S.A.  . . . . . . .

175878

International Investments Corporation S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

175876

International Radio Networks Holding S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

175876

IRERE Property Investments (French Offi-

ces)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

175876

Isel S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

175879

Ixora Developpement S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

175878

Josephine S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

175879

Just-eat.lu S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

175879

KA Communications Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . .

175882

Kaloo S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

175890

Kauri Broadway Properties S.à r.l.  . . . . . . .

175878

Kelapa Capital  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

175881

KLS SPF S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

175881

KWL S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

175878

Lord's Walk S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

175880

Lubex Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

175880

Lubex Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

175881

Lux 48 Starlight GBP S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

175900

Lux Flex  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

175881

LuxTram S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

175882

Lyxor Titrisation 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

175880

Montblanc Management S.à r.l. . . . . . . . . . .

175918

Nido London Properties S.à r.l. . . . . . . . . . .

175884

Open Eyes Invest S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

175911

Petroleum Services Properties S.A. . . . . . .

175910

Preafin III S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

175913

Trial Quatre S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

175875

Vemainvest S.A.-SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

175875

Willemite Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . .

175875

Wodalux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

175875

Wolmar Investments S. à r.l.  . . . . . . . . . . . .

175874

175873

L

U X E M B O U R G

Ceasar International S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3364 Leudelange, 1, rue de la Poudrerie.

R.C.S. Luxembourg B 153.539.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 69592 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014173510/10.
(140198507) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.

Centre Chretien-Social du Sud, Société Coopérative.

Siège social: L-1351 Luxembourg, 11, rue du Commerce.

R.C.S. Luxembourg B 7.236.

Le Bilan abrégé au 31 Décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 novembre 2014.

Référence de publication: 2014173513/10.
(140198570) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.

ArcelorMittal, Société Anonyme.

Siège social: L-1160 Luxembourg, 24-26, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 82.454.

Le Conseil d'administration, lors de sa réunion du 6 novembre 2014, a décidé de transférer le siège social de la société

du 19 avenue de la Liberté, L-2930 Luxembourg, au 24-26 boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 10 novembre 2014.

Référence de publication: 2014173415/11.
(140198830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.

ArcelorMittal, Société Anonyme.

Siège social: L-1160 Luxembourg, 24-26, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 82.454.

L'adresse professionnelle de Monsieur Gonzalo Urquijo Fernandez de Araoz, Membre de la direction générale, est

désormais au 24-26 boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 10 novembre 2014.

Référence de publication: 2014173417/11.
(140199465) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.

Wolmar Investments S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 115.802.

Les comptes annuels de la société au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2014174220/12.
(140199057) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.

175874

L

U X E M B O U R G

Vemainvest S.A.-SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 179.441.

Les comptes annuels au 31-12-2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014174206/9.
(140198348) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.

Trial Quatre S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1463 Luxembourg, 29, rue Fort Elisabeth.

R.C.S. Luxembourg B 87.040.

Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

PINHEIRO Samantha.

Référence de publication: 2014174161/10.
(140199007) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.

Wodalux S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.
Siège social: L-6633 Wasserbillig, 19, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 121.760.

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration de la société Wodalux S.A., qui s'est tenue à Wasserbillig en date du 6 novembre

<i>2014.

Le Conseil d'Administration a:
- Décidé de nommer la société Fiduciaire Scheiwen - Nickels &amp; Associés S.à r.l., établie et ayant son siège social à

13-15, Breedewues, L-1259 Senningerberg, inscrite au registre de commerce de Luxembourg, section B, sous le numéro
55.475 comme dépositaire de ses titres au porteur.

Senningerberg, le 10 novembre 2014.

<i>Pour la société
Mandataire

Référence de publication: 2014174233/16.
(140199275) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.

Willemite Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 118.616.

Lors de l'assemblée générale annuelle en date du 20 octobre 2014, les actionnaires ont pris les décisions suivantes:
1. Renouvellement du mandat des administrateurs suivants:
- José Correia, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L- 1882 Luxembourg
- Géraldine Schmit, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L- 1882 Luxembourg
- Christophe Davezac, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L- 1882 Luxembourg
pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice

social se clôturant au 31 décembre 2014 et qui se tiendra en 2015;

2. Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes de READ S.à.r.l., avec siège social au 3A, Boulevard Prince

Henri, L-1724 Luxembourg pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur
les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2014 et qui se tiendra en 2015;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 novembre 2014.

Référence de publication: 2014174229/19.
(140198862) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.

175875

L

U X E M B O U R G

International Investments Corporation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 47, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 172.304.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014174658/9.
(140199503) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2014.

Intercontinental Group for Commerce Industry and Finance S.A., SPF, Société Anonyme - Société de

Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 14.070.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014174653/11.
(140199226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2014.

International Radio Networks Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 75.960.

Les comptes annuels audités au 31 décembre 2013, ainsi que les informations et documents annexes ont été déposés

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 novembre 2014.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014174660/13.
(140199935) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2014.

IRERE Property Investments (French Offices), Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.525,00.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 117.075.

EXTRAIT

L'associé unique, dans ses résolutions du 11 novembre 2014 a renouvelé les mandats des gérants.
- Mrs Stéphanie GRISIUS, M. Phil. Finance B. Sc. Economics, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, gérant de catégorie

B.

- Mr Manuel HACK, maître ès sciences économiques, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, gérant de catégorie B.
- Mr Laurent HEILIGER, licencié en sciences commerciales et financières, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, gérant

de catégorie B.

- Mr Timothy THORP, chartered accountant, 12, Charles II Street, SW1Y 4QU Londres, Royaume-Uni, gérant de

catégorie A.

Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2014.

Luxembourg, le 11 novembre 2014.

<i>Pour IRERE PROPERTY INVESTMENTS (FRENCH OFFICES)
Société à responsabilité limitée

Référence de publication: 2014174664/21.
(140200320) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2014.

175876

L

U X E M B O U R G

Incentive Travel International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 5, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 148.421.

Le bilan et annexes au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014174651/9.
(140199820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2014.

Iena Participations S.à r.l., Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.

Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, rives de Clausen.

R.C.S. Luxembourg B 140.451.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014174647/9.
(140200230) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2014.

Immo-Ardennes s.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9676 Noertrange, 17, Op der Hekt.

R.C.S. Luxembourg B 94.664.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Clervaux, le 11 novembre 2014.

Référence de publication: 2014174649/10.
(140200077) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2014.

Inteclux Software Engineering S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 38, Gruuss-Strooss.

R.C.S. Luxembourg B 92.104.

<i>Auszug aus dem Protokoll der Jahreshauptversammlung vom 20. Juni 2014

Es wurde beschlossen, die Mandate der folgenden im Amt befindlichen Verwaltungsratsmitglieder für die Dauer von

sechs Jahren bis zum Ablauf der Generalversammlung des Jahres 2020 zu verlängern, und zwar:

- Herr Oswald HENKES, Informatiker, wohnhaft in B-4760 Manderfeld, Lanzerath 39A, Verwaltungsratsmitglied, De-

legierter und Vorsitzender des Verwaltungsrates;

- Herr André ENGEL, Bankangestellter, wohnhaft in B-4950 Waimes, Bruyères 103, Verwaltungsratsmitglied.
Es wurde ebenfalls beschlossen, mit sofortiger Wirkung, zu neuen Verwaltungsratsmitgliedern zu ernennen:
- Herr Andreas CLASSEN, Informatiker, wohnhaft in B-4770 Born, Zur Hülsburg 8, Verwaltungsratsmitglied und De-

legierter des Verwaltungsrates;

- Herr Michael HENKES, Informatiker, wohnhaft in B-4760 Manderfeld, Lanzerath 39A, Verwaltungsratsmitglied;
- Herr GREIMERS Thomas, Informatiker, wohnhaft in B-4760 Büllingen, Hünningen 129/B, Verwaltungsratsmitglied.
Die Mandate enden mit Ablauf der Generalversammlung des Jahres 2020
Die Jahreshauptversammlung beschließt ebenfalls, das Mandat des Kommissars Herr Joseph FAYMONVILLE, wohnhaft

in B - 4780 St. Vith, Prümer Strasse 8, für die Dauer von sechs Jahren zu verlängern. Das Mandat des Kommissars endet
mit Ablauf der Generalversammlung des Jahres 2020.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, den 11. November 2014.

<i>Für INTECLUX SOFTWARE ENGINEERING S.A., Aktiengesellschaft
FIDUNORD S.à r.l.

Référence de publication: 2014174652/26.
(140200256) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2014.

175877

L

U X E M B O U R G

Kauri Broadway Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue John F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 129.349.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 04 Novembre 2014.

Référence de publication: 2014174679/10.
(140199510) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2014.

International Fair Consulting S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 28, Gruuss Strooss.

R.C.S. Luxembourg B 50.123.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 mit allen dazugehörigen Unterlagen wurde beim Handels- und Gesell-

schaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

INTERNATIONAL FAIR CONSULTING S.A.

Référence de publication: 2014174657/11.
(140200161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2014.

Ixora Developpement S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1740 Luxembourg, 20, rue de Hollerich.

R.C.S. Luxembourg B 162.125.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 08 octobre 2014

Il résulte de l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société en date du 08 octobre 2014 une

résolution unique:

L'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires prend acte que le siège social de la Société est transféré à L -

1740 Luxembourg, 20, Rue de Hollerich, à compter du 1 

er

 novembre 2014.

Luxembourg, le 08 octobre 2014.

Pour extrait conforme
<i>Pour la Société
Un mandataire

Référence de publication: 2014174667/16.
(140199633) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2014.

KWL S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 135.179.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 6 novembre 2014, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en

matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
la dissolution et la liquidation de la société KWL SARL, avec siège social à L-4041 Esch-sur-Alzette, 17, rue du Brill, de
fait inconnue à cette adresse

Le même jugement a nommé juge-commissaire Madame Anita LECUIT et liquidateur Maître Yasemin CENGIZ-KIYAK,

avocat, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration du montant de leurs créances avant le 27 novembre 2014 au greffe

de la sixième chambre de ce Tribunal

Pour extrait conforme
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2014174685/17.
(140200068) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2014.

175878

L

U X E M B O U R G

Isel S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 9, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 157.302.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014174665/10.
(140199594) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2014.

International Equity Investors S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 65.461.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014174656/10.
(140200277) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2014.

Josephine S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5810 Hesperange, 43, rue de Bettembourg.

R.C.S. Luxembourg B 170.053.

Le bilan au 31.12.2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 novembre 2014.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L-1013 Luxembourg

Référence de publication: 2014174672/14.
(140199630) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2014.

Just-eat.lu S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: DKK 95.001,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 176.212.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l'associé unique de la Société du 4 novembre 2014 que:
- La démission de M. Philippe SALPETIER, gérant de catégorie B de la Société, avec effet au 31 octobre 2014, a été

acceptée.

- La personne suivante a été nommée gérant de catégorie B de la Société, avec effet au 31 octobre 2014 et ce pour

une durée indéterminée:

* Mr Marc Chong Kan, né le 24 août 1964 à Paris, France, résidant professionnellement au 16, avenue Pasteur L-2310

Luxembourg.

La Société prend acte de la nouvelle adresse de Monsieur Patrick MOINET au 156, rue Albert Unden, L-2652 Lu-

xembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 novembre 2014.

Référence de publication: 2014174669/20.
(140199906) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2014.

175879

L

U X E M B O U R G

Lyxor Titrisation 1, Société à responsabilité limitée de titrisation.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 179.339.

Par résolutions prises en date du 27 octobre 2014, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Nomination de Joël Autissier, avec adresse professionnelle au 11, avenue Emile Reuter, L- 2420 Luxembourg, au

mandat de gérant, avec effet au 30 octobre 2014 et pour une durée indéterminée;

2. Nomination d'Amaury Gros de Beler, avec adresse professionnelle au 11, avenue Emile Reuter, L- 2420 Luxembourg,

au mandat de gérant, avec effet au 30 octobre 2014 et pour une durée indéterminée;

3. Acceptation de la démission d'Eric Talleux, avec adresse professionnelle au 17, cours Valmy, Tour Société Générale,

92987 Paris La Défense, France de son mandat de gérant, avec effet au 30 octobre 2014;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 novembre 2014.

Référence de publication: 2014174710/17.
(140200283) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2014.

Lord's Walk S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 12.610,00.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 189.626.

<i>Extrait de la résolution adoptée par l'associé unique de la Société à Luxembourg en date du 7 novembre 2014

Il résulte de la résolution adoptée par l'associé unique de la Société en date du 7 novembre 2014 qu'il a été décidé de:
1. Elire, la Société Deloitte Audit, société à responsabilité limitée dont le siège social est situé au 560, Rue de Neudorf,

L-2220 Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 67.895,
en tant que Réviseur d'Entreprises Agréé jusqu'à l'assemblée générale ordinaire annuelle des associés devant se tenir en
l'année 2015 pour statuer sur l'approbation des comptes annuels au 31 décembre 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 11 novembre 2014.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2014174694/18.
(140200326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2014.

Lubex Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9764 Marnach, 21, rue de Marbourg.

R.C.S. Luxembourg B 90.956.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue au siège de la société, extraordinairement en date du 3 septembre

<i>2014 à 14.00 heures

L'assemblée générale ordinaire renouvelle jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2020 les mandats

des administrateurs suivants:

Marc  REIFF,  administrateur  et  administrateur  délégué,  né  à  Ettelbruck  (L)  le  17.06.1972,  demeurant  à  L  -  9263  -

Diekirch, 24, Rue Jean l'Aveugle

Mario REIFF, administrateur, né à Ettelbruck (L) le 23.11.1970, demeurant à L - 9232 Diekirch, 49, Am Floss
Joseph MEYER, administrateur, né à St. Vith (B) le 08.04.1955, demeurant à B - 4782 Schönberg, 19, Zum Burren
Le mandat du commissaire aux comptes Edith REIFF, née à Ettelbruck (L) le 13.02.1968, demeurant à L - 9254 Diekirch,

6, Rue de Larochette est également renouvelé jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2020.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Un administrateur

Référence de publication: 2014174695/19.
(140199653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2014.

175880

L

U X E M B O U R G

KLS SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du Dix Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 155.333.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014174681/9.
(140199730) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2014.

Kelapa Capital, Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 181.777.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 novembre 2014.

Référence de publication: 2014174680/10.
(140200285) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2014.

Lubex Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9764 Marnach, 21, rue de Marbourg.

R.C.S. Luxembourg B 90.956.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue au siège de la société en date du 27 octobre 2014 à 15.00

<i>heures

L'assemblée générale nomme au poste d'administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2020,

Madame Julia MEYER, née à St. Vith (B) le 27.04.1985, demeurant à B - 4782 Schönberg, 17, Zum Bürren.

Ainsi le nombre des administrateurs passe de 3 à 4 membres.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Un administrateur

Référence de publication: 2014174696/14.
(140199653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2014.

Lux Flex, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 155.038.

L'assemblée générale ordinaire du 8 mai 2014 a décidé de renouveler les mandais de Messieurs Philippe Bernard,

Eduard von Kymmel et Heinrich Hugenschmidt en tant que membres du conseil d'administration de Lux Flex.

Par conséquent, le conseil d'administration se compose dorénavant comme suit et ce jusqu'à la fin de la prochaine

assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2015

- Philippe Bernard, Membre du Conseil d'Administration
56, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg
- Eduard von Kymmel, Membre du Conseil d'Administration
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
- Heinrich Hugenschmidt, Membre du Conseil d'Administration
8, Paradeplatz, CH-8070 Zurich
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative a été réélu comme réviseur d'entreprises, et ce jusqu'à la fin de la

prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

CREDIT SUISSE FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.

Référence de publication: 2014174697/21.
(140199741) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2014.

175881

L

U X E M B O U R G

International Brands Promotion S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 43.667.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014174654/9.
(140199784) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2014.

KA Communications Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6477 Echternach, 50, rue des Remparts.

R.C.S. Luxembourg B 80.821.

Der Jahresabschluss vom 31.12.2013 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Hierbei handelt es sich um eine berichtigte Einreichung betreffend die Einreichung vom 17.04.2014 mit der Referenz
L140063869.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014174676/11.
(140200275) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2014.

Iceberg International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 183.834.

II est pris note du changement d'adresse du gérant suivant avec effet au 29 octobre 2014:
Mr Eugenio Minvielle Lagos, gérant de catégorie A, avec adresse professionnelle au 3 Beaty Court, Rye, New York

10580, Etats-Unis d'Amérique.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 novembre 2014.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014174643/15.
(140199795) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2014.

LuxTram S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 24, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 191.146.

<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration de la Société en date du 21 octobre 2014

En date du 21 octobre 2014, le conseil d'administration de la Société a pris les résolutions suivantes:
- de nommer Monsieur René BIWER, actuel administrateur de catégorie A, en tant que Président du conseil d'admi-

nistration de la Société avec effet immédiat et ce pour la durée de son mandat d'administrateur de catégorie A de la
Société jusqu'à l'assemblée générale annuelle de la Société qui se tiendra en l'année 2019;

- de nommer Monsieur Paul HOFFMANN, actuel administrateur de catégorie B, en tant que Vice-Président du conseil

d'administration de la Société avec effet immédiat et ce pour la durée de son mandat d'administrateur de catégorie B de
la Société jusqu'à l'assemblée générale annuelle de la Société qui se tiendra en l'année 2019.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 novembre 2014.

LuxTram S.A.
Signature

Référence de publication: 2014174709/19.
(140199739) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2014.

175882

L

U X E M B O U R G

CC Global Investments Master Fund, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV -

Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 2, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 168.363.

In the year two thousand and fourteen, on the eighth of October.
Before us Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held

the extraordinary general meeting (the "General Meeting") of the shareholders of “CC GLOBAL INVESTMENTS

MASTER FUND”, a partnership limited by shares (société en commandite par actions) qualifying as an investment company
with variable share capital - specialised investment fund (société d’investissement à capital variable - Fonds d'investissement
spécialisé), registered on the official list of specialized investment funds governed by the law of February 13 

th

 , 2007, as

amended, having its registered office at 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, incorporated under the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg on April 19 

th

 , 2012, pursuant to a deed of the notary Maître Henri HELLINCKX, then

notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 1199 of May 12

th

 , 2012,

registered with the Luxembourg trade and companies' register under number B 168.363 (the "Company").
The Extraordinary General Meeting was opened at 04:30 p.m. with Me Jonathan BURGER, Avocat à la Cour, with

professional address in Luxembourg, as chairman.

The President appoints as secretary Mrs. Anne-Laure ADAM, employee, with professional address in Luxembourg.

The Meeting elects as scrutineer Me Sze-suen LI, Avocat, with professional address in Luxembourg,

The board of the Extraordinary General Meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested

the notary to state:

I. That the agenda of the Extraordinary General Meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Transfer of the registered office of the Company to 2, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg with immediate

effect.

2. Restatement of Article 2.1 as follows: "The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It

may be transferred to any other place within the Grand-Duchy of Luxembourg by a general meeting of shareholders of
the Company deliberating in the manner provided for amendments to the Articles. It may be transferred within the
boundaries of the municipality by a resolution of the General Partner (as defined in Article 15 below), if and to the extent
permitted under the Companies Act ".

II. That the shareholders represented, the proxyholder of the represented shareholders and the number of their shares

are shown on an attendance list; this attendance list, signed “ne varietur” by the proxyholder of the represented share-
holder and by the board of the Extraordinary General Meeting, will remain attached to the present deed in order to be
registered therewith.

The proxies of the represented shareholders, initialed "ne varietur" by the appearing party, will also remain annexed

to the present deed.

III. That it appears from the attendance list mentioned that out of two thousand three hundred seventy three point

zero  seventeen  (2,373.017)  outstanding  shares,  two  thousand  three  hundred  seventy  three  point  zero  seventeen
(2,373.017) shares are duly present or represented at the present General Meeting. In consideration of the agenda and
of the provisions of Article 67 and 67-1 of the law on commercial companies, the meeting is validly constituted and
therefore entitled to decide on the items of the agenda.

VI. That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting
and that no convening notices were necessary.

After deliberation, the General Meeting took the following resolutions by more than two-third majority votes cast, as

detailed in the attendance list:

<i>First resolution

The General Meeting resolves to transfer the registered office of the Company to 2, boulevard de la Foire, L-1528

Luxembourg with immediate effect.

<i>Second resolution

The General Meeting resolves to restate Article 2.1 as follows:
"The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be transferred to any other place

within the Grand-Duchy of Luxembourg by a general meeting of shareholders of the Company deliberating in the manner

175883

L

U X E M B O U R G

provided for amendments to the Articles. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution
of the General Partner (as defined in Article 15 below), if and to the extent permitted by the Companies Act ".

There being no further business on the agenda, the Chairman has adjourned the General Meeting at 04:45 p.m.

<i>Costs

The aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company

incurs or for which it is liable by reason of the present amendments, is approximately nine hundred Euro (EUR 900.-).

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English.

The document having been read to the meeting, the members of the board of the meeting, all of whom are known to

the notary by their names, family names, civil status and residences, signed together with us, the notary, the pre-sent
original deed, no shareholder expressing the wish to sign.

Signé: J. BURGER, AL. ADAM, SS. LI, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 13 octobre 2014. LAC/2014/47638. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur ff.

 (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 05 novembre 2014.

Référence de publication: 2014171156/75.
(140196149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2014.

Nido London Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 156.175.

In the year two thousand fourteen, the twenty-sixth day of September,
before Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

“Nido London S.à r.l.”, a private limited company Luxembourg, having its registered office at 13-15, avenue de la Liberté,

L-1931 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and
Companies (R.C.S. Luxembourg) under number B 162.742 (the Sole Shareholder),

the above appearing party being hereby represented by Mrs. Aleksandra SAJKIEWICZ, lawyer, professionally residing

in Luxembourg, by virtue of a sole (1) proxy given under private seal.

Said proxy, after having been signed “ne varietur” by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The appearing party, represented as aforesaid, is the sole shareholder of “Nido London Properties S.à r.l.”, a private

limited liability company (société à responsabilité limitée) duly organized and existing under the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg, having its registered office at 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg, incorporated on September 24th, 2010 pursuant to a deed of Maître Francis KESSELER, notary residing in Esch-
sur-Alzette, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on November 25 

th

 , 2010 under number

2568,

registered with the Register of Commerce and Companies (R.C.S. Luxembourg) under number B 156.175 (the Com-

pany).

The articles of association of the Company (the Articles) have been amended for the last time pursuant to a deed of

Maître Francis KESSELER, notary residing in Esch-sur-Alzette, on 21 May 2012, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations on 18 July 2012 under number 1809.

The Sole Shareholder, represented as aforesaid and representing the entirely of the share capital, has requested the

undersigned notary to act the resolutions contained into the following agenda:

<i>Agenda:

1. Change of the financial year of the Company so that such financial year begins on the first (1) of August of each year

and ends on the thirty-first (31) of July of the following year, it being understood that the current financial year, which
started on 1 January 2014, shall be ended as of 31 July 2014;

2. Amendment to articles 16 and 17 of the Articles of the Company in order to reflect the change of financial year

specified under item (1.) above; and

3. Miscellaneous.

175884

L

U X E M B O U R G

<i>Sole resolution

The Sole Shareholder resolves to change the financial year of the Company so that such financial year begins on the

first (1) of August of each year and ends on the thirty-first (31) of July of the following year.

In light of the above, the Sole Shareholder resolves to amend articles 16 and 17 of the Articles of the Company, so

that it shall henceforth read as follows:

“ 16. The financial year begins on the first (1) of August of each year and ends on the thirty-first (31) of July of the

following year.”

“ 17. Each year on the thirty-first (31) of July, the books are closed and the managers prepare an inventory including

an indication of the value of the Company's assets and liabilities.”

As a consequence of the foregoing, the Sole Shareholder acknowledges that the current financial year, which started

retroactively on 1 January 2014, shall be ended retroactively as of 31 July 2014; and the new financial year shall begin with
effect as of 1 August 2014 and end on 31 July 2015.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately eight hundred Euro (EUR 800.-).

WHEREOF, The present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the proxyholder of the appearing parties

signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille quatorze, le vingt-six septembre,
Par-devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

ONT COMPARU:

1. «Nido London S.à r.l.», une société à responsabilité limitée, dont le siège social se situe au 13-15, avenue de la

Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
Luxembourg (R.C.S. Luxembourg), sous le numéro B 162.742 (l’Associé Unique),

représentée par Me Aleksandra SAJKIEWICZ, avocate, demeurant professionnellement à Luxembourg, Grand-Duché

de Luxembourg, en vertu d'une unique (1) procuration donnée sous seing privé.

Laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par la mandataire agissant pour le compte de la partie

comparante et par le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour les besoins de l’enregistrement.

La comparante, représentée comme ci-avant, est la seule et unique associée (l’«Associé Unique») de «Nido London

Properties S.à r.l.», une société à responsabilité limitée régie et constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg,
dont le siège social se situe au 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée
le 24 Septembre 2010 suivant un acte de Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché
de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 21 Mai 2012 numéro 2568,

immatriculée  au  Registre  du  Commerce  et  des  Sociétés  de  Luxembourg  (R.C.S.  Luxembourg)  sous  le  numéro  B

156.175 (la Société).

Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés la dernière fois suivant un acte reçu par Maître Francis KESSELER,

notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, le 21 Mai 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le
18 Juillet 2012 numéro 1809.

L'Associé Unique, représenté comme ci-avant et représentant l’intégralité du capital social, a requis le notaire instru-

mentant d’acter les résolutions contenues dans l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Changement de l’année sociale de la Société afin que l’année sociale commence le premier (1) août de chaque année

et s'achève le trente et un (31) juillet de l’année suivante, étant entendu que l’année sociale en cours, qui a commencé le
1 janvier 2014, s'achèvera au 31 juillet 2014;

2. Modification des articles 16 et 17 des statuts de la Société afin de refléter le changement d’exercice social défini au

point (1.) ci-dessus; et

3. Divers.

175885

L

U X E M B O U R G

<i>Résolution unique

L'Associé Unique décide de changer l’année sociale de la Société afin que l’année sociale commence le premier (1)

août de chaque année et s'achève le trente-et-un (31) juillet de l’année suivante.

Au vu la décision précédente, l’Associé Unique décide de modifier les articles 16 et 17 des Statuts, de sorte qu'ils

auront désormais la teneur suivante:

« 16. L’exercice social commence le premier août de chaque année et se termine le trente-et-un juillet de l’année

suivante.»

« 17. Chaque année les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant les indications

de valeurs actives et passives de la Société.»

En conséquence de ce qui précède, l’Associé Unique prend acte que l’année sociale en cours, qui a commencé rétro-

activement le 1 janvier 2014, s'achèvera rétroactivement au 31 juillet 2014; et la nouvelle année sociale prendra effet au
1 août 2014 et s'achèvera au 31 juillet 2015.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en

conséquence du présent acte sont estimés à environ huit cents Euros (EUR 800,-).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date stipulée au début des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante susnommée, le

présent acte est rédigé en anglais, suivi d’une version française, à la demande de la même partie comparante, en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Le document ayant été lu au mandataire de la partie comparante, le mandataire de la partie comparante a signé avec

le notaire instrumentant le présent acte original.

Signé: A. SAJKIEWICZ, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 octobre 2014. LAC/2014/45760. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 30 octobre 2014.

Référence de publication: 2014170567/114.
(140195103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2014.

Bravida HoldCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2C, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 122.235.

In the year two thousand fourteen, on the eighth of October.
Before Maître Marc Loesch, notary, residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,

was held

an extraordinary general meeting of shareholders of Bravida HoldCo S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed

by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of two million two hundred fourteen thousand
eight hundred Swedish Kronor (SEK 2,214,800.-), with registered office at 2C, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of Maître Martine Schaeffer, notary then residing in Remich,
Grand Duchy of Luxembourg, dated 1 December 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
dated 2 February 2007 number 105 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under
number B 122.235 (the "Company"). The articles of incorporation of the Company have for the last time been amended
following a deed of the undersigned notary, of 2 August 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations dated 8 September 2012 number 2236.

The extraordinary general meeting is declared open at 11.20 a.m., with Me Catherine Kremer, lawyer, residing in

Luxembourg, in the chair,

who appointed as secretary Me Maxime Roland, lawyer, residing in Luxembourg.
The extraordinary general meeting elected as scrutineer Me Nathalie Blanc, lawyer, residing in Luxembourg.
The board of the extraordinary general meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested

the notary to state:

(i) The agenda of the extraordinary general meeting is the following:

175886

L

U X E M B O U R G

<i>Agenda

1. To approve the buy-back by the Company of all four thousand nine hundred (4,900) class E shares (the “Class E

Shares”) held by its shareholders and to approve the determination by the Company’s managers of the purchase price
for the Class E Shares.

2. Further to the approval of the buy-back of the Class E Shares by the Company, to acknowledge that the Company

holds all of its Class E Shares, with a nominal value of two hundred twenty-six Swedish Kronor (SEK 226.-) each.

3. To decrease the share capital of the Company by an amount of one million one hundred seven thousand four hundred

Swedish Kronor (SEK 1,107,400.-) so as to reduce it from its current amount of two million two hundred fourteen
thousand eight hundred Swedish Kronor (SEK 2,214,800.-) to one million one hundred seven thousand four hundred
Swedish Kronor (SEK 1,107,400.-) by cancellation of all Class E Shares, each having a nominal value of two hundred
twenty-six Swedish Kronor (SEK 226.-).

4. To amend the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation of the Company so as to reflect the foregoing

items of the agenda.

5. To confer all and any power to the managers of the Company in order to implement the above.
6. Miscellaneous.
(ii) The shareholders present, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown

on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders and
by the board of the extraordinary general meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time
with the registration authorities.

(iii) The proxies of the represented shareholders, initialled "ne varietur" by the appearing parties will also remain

annexed to the present deed.

(iv) The whole subscribed capital being represented at the present extraordinary general meeting and all the share-

holders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this
extraordinary general meeting, no convening notices were necessary.

(v) The present extraordinary general meeting is then regularly constituted and may validly deliberate on all the items

of the agenda.

The extraordinary general meeting resolved, after deliberation, unanimously to take the following resolutions:

<i>First resolution

The extraordinary general meeting of shareholders resolved to approve the buy-back by the Company of the Class E

Shares held by its shareholders and to authorise the Company’s manager to determine the purchase price for the Class
E Shares.

<i>Second resolution

Further to the approval of the buy-back of the Class E Shares the Company, the extraordinary general meeting of

shareholders resolved to acknowledge that the Company holds all the Class E Shares, with a nominal value of two hundred
twenty-six Swedish Kronor (SEK 226.-) each.

<i>Third resolution

The extraordinary general meeting of shareholders resolved to decrease the share capital of the Company by an

amount of one million one hundred seven thousand four hundred Swedish Kronor (SEK 1,107,400.-) so as to reduce it
from its current amount of two million two hundred fourteen thousand eight hundred Swedish Kronor (SEK 2,214,800.-)
to one million one hundred seven thousand four hundred Swedish Kronor (SEK 1,107,400.-) by cancellation of all Class
E Shares, having each a nominal value of two hundred twenty-six Swedish Kronor (SEK 226.-).

<i>Fourth resolution

The extraordinary general meeting of shareholders resolved to amend the first paragraph of article 5 of the articles

of incorporation of the Company as a result of the foregoing resolutions, which shall henceforth read as follows:

“ Art. 5. Subscribed capital. The subscribed capital of the Company is set at one million one hundred seven thousand

four hundred Swedish Kronor (SEK 1,107,400.00) represented by four thousand nine hundred (4,900) class D shares (the
“Class D Shares”), each with a nominal value of two hundred twenty-six Swedish Kronor (SEK 226.-), all of which are
fully paid up.”

<i>Fifth resolution

The extraordinary general meeting resolves to confer all and any powers to the managers of the Company in order

to implement the above resolutions.

Each manager of the Company is notably entitled and authorised to pay out, in cash or in kind, the consideration for

the cancellation of the Class E Shares in an aggregate amount of one million one hundred seven thousand four hundred

175887

L

U X E M B O U R G

Swedish Kronor (SEK 1,107,400.-) to the shareholders, to set the date and other formalities of such payment and to do
all other things necessary and useful in relation to the above resolutions.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed

are estimated at two thousand five hundred euro (EUR 2,500.-).

There being no other business, the extraordinary general meeting was adjourned at 11.30 a.m..

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of divergences
between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name,

civil status and residence, the said persons signed together with Us notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le huitième jour d’octobre.
Par devant Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est réunie

l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société Bravida HoldCo S.à r.l., une société à responsabilité

limitée régie par la loi du Grand-Duché de Luxembourg, avec un capital social de deux millions deux cent quatorze mille
huit cents couronnes suédoises (SEK 2.214.800,-), ayant son siège social au 2C, rue Albert Borschette, L-1246 Luxem-
bourg, Grand-Duché du Luxembourg, constituée par un acte de Maître Martine Schaeffer, notaire alors de résidence à
Remich, Grand-Duché de Luxembourg, du 1 

er

 décembre 2006 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations

le 2 février 2007, numéro 105 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 122.235 (la «Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par un acte du notaire instru-
mentant, le 2 août 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 8 septembre 2012, numéro 2236.

L’assemblée générale extraordinaire est ouverte à 11.20 heures sous la présidence de Maître Catherine Kremer, avocat,

demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Maître Maxime Roland, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée générale extraordinaire choisit comme scrutateur Madame Nathalie Blanc, juriste, demeurant à Luxem-

bourg.

Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
(i) La présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour

1. Approbation du rachat par la Société de toutes ses quatre mille neuf cents (4,900) parts sociales de catégorie E (les

“Parts Sociales de Catégorie E”) détenues par ses associés et approbation de la détermination par les gérants de la Société
du prix de rachat des Parts Sociales de Catégorie E.

2. Suite à l’approbation du rachat des Parts Sociales de Catégorie E par la Société, constatation de la détention par la

Société des Parts Sociales de Catégorie E, chacune ayant une valeur nominale de deux cent vingt-six couronnes suédoises
(SEK 226,-).

3. Réduction du capital social souscrit de la Société d’un montant d’un million cent sept mille quatre cents couronnes

suédoises (SEK 1.107.400,-) afin de le réduire de son montant actuel de deux millions deux cent quatorze mille huit cents
couronnes suédoises (SEK 2.214.800,-) à un montant d’un million cent sept mille quatre cents couronnes suédoises (SEK
1.107.400,-) par annulation de tous les Parts Sociales de Catégorie E ayant une valeur nominale de deux cent vingt-six
couronnes suédoises (SEK 226,-).

4. Modification du paragraphe 1 

er

 de l’article 5 des statuts de la Société afin de refléter les points de l’ordre du jour

ci-dessus.

5. Délégation de pouvoirs au gérant de la Société afin de mettre en oeuvre les points ci-dessus.
6. Divers.
(ii) Les associés présents, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre de parts sociales qu'ils dé-

tiennent, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les associés présents,
les mandataires des associés représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal
pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

(iii) Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des associés représentés, après avoir été para-

phées "ne varietur" par les comparants.

175888

L

U X E M B O U R G

(iv) L'intégralité du capital social souscrit étant représentée à la présente assemblée générale extraordinaire, il a pu

être fait abstraction des convocations d'usage, les associés présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués
et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

(v) La présente assemblée générale extraordinaire est ainsi régulièrement constituée et peut délibérer valablement,

telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L'assemblée générale extraordinaire, après avoir délibéré, a alors pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire des associés a décidé d’approuver le rachat par la Société de toutes les Parts

Sociales de Catégorie E détenues par ses associés et d’autoriser les gérants de la Société de déterminer le prix d’achat
des Parts Sociales de Catégorie E.

<i>Deuxième résolution

Suite à l’approbation du rachat des Parts Sociales de Catégorie E par la Société, l’assemblée générale extraordinaire

des associés a décidé de constater la détention par la Société des Parts Sociales de Catégorie E, chacune ayant une valeur
nominale de deux cents vingt-six couronnes suédoises (SEK 226,-).

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale extraordinaire a décidé de réduire le capital social souscrit de la Société d’un montant d’un million

cent sept mille quatre cents couronnes suédoises (SEK 1.107.400,-) afin de le réduire de son montant actuel de deux
millions deux cent quatorze mille huit cents couronnes suédoises (SEK 2.214.800,-) à un montant d’un million cent sept
mille quatre cents couronnes suédoises (SEK 1.107.400,-) par annulation de toutes les Parts Sociales de Catégorie E ayant
chacune une valeur nominale de deux cent vingt-six couronnes suédoises (SEK 226,-).

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des associés a décidé de modifier le paragraphe 1 

er

 de l’article 5 des statuts de

la Société qui aura dorénavant la teneur suivante:

“ Art. 5. Capital social souscrit. Le capital social souscrit de la Société est fixé à un million cent sept mille quatre cent

couronnes suédoises (SEK 1.107.400,-) représenté par quatre mille neuf cents (4.900) Parts Sociales de Catégorie D (the
«Parts Sociales de Catégorie D»), ayant une valeur nominale de deux cent vingt-six couronnes suédoises (SEK 226,-)
chacune, chaque part sociale étant entièrement libérée.”

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale extraordinaire a décidé de conférer tous les pouvoirs aux gérants de la Société pour mettre en

oeuvre les résolutions prises ci-dessus.

Chaque gérant de la Société est notamment mandaté et autorisé à payer, en espèces ou en nature, la contrepartie

pour l’annulation de ces Parts Sociales de Catégorie E d’un montant total d’un million cent sept mille quatre cents cou-
ronnes suédoises (SEK 1.107.400,-) aux associés, à fixer la date et toute autre modalité de ces paiements, et à prendre
toute autre mesure nécessaire et utile en relation avec les résolutions prises ci-dessus.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont

estimés à deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-).

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à 11.30 heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci

avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; à la demande des même comparants, et
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leur nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: C. Kremer, M. Roland, N. Blanc, M. Loesch.
Enregistré à Remich, le 10 octobre 2014. REM/2014/2232. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 5 novembre 2014.

Référence de publication: 2014171111/181.
(140195996) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2014.

175889

L

U X E M B O U R G

Kaloo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 191.682.

STATUTES

In the year two thousand and fourteen, on the seventeenth day of October,
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

Aviston Financial Corp., a BVI Business Company having its address at c/o Aleman, Cordero, Galindo &amp; Lee Trust

(BVI)  Limited,  P.O.  Box  3175,  Road  Town,  Tortola,  British  Virgin  Islands  registered  under  the  British  Virgin  Islands
company identification number 460342 (Aviston),

here represented by Régis Galiotto, notary clerk, with professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-

bourg, by virtue of a power of attorney given under private seal;

Vertex Financial Holdings, Ltd., a limited company incorporated under the laws of the British Virgin Islands and having

its registered office in Marcy Building, 2 

nd

 floor, Purcell Estate, P.O. Box 2416, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

registered under the British Virgin Islands company identification number 1778490 (Vertex, and together with Aviston,
the Shareholders),

here represented by Régis Galiotto, notary clerk, with professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-

bourg, by virtue of a power of attorney given under private seal;

Such powers of attorney, after having been signed ne varietur by the representative of the appearing parties and the

undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

The appearing parties, represented as described above, have requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. The name of the company is “Kaloo S.à r.l.” (the Company). The Company is a private limited liability

company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and, in particular,
the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation (the
Articles).

Art. 2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be

transferred within the municipality by a resolution of the board of managers. The registered office may be transferred to
any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the
conditions prescribed for the amendment of the Articles.

2.2 Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a

resolution of the board of managers. Where the board of managers determines that extraordinary political or military
developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events may interfere with the
normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and
persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these cir-
cumstances. Such temporary measures have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, remains a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Corporate object.
3.1 The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign

companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development
of its portfolio.

3.2 An additional purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand

Duchy of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including the direct or indirect
holding of participation in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition, development,
promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.

3.3 The Company may further guarantee, grant security in favour of third parties to secure its obligations or the

obligations of companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of
companies as the Company, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect partici-
pation or which form part of the same group of companies as the Company or any third parties.

175890

L

U X E M B O U R G

3.4 The Company may carry out any commercial, industrial, financial or intellectual property activities which it may

deem useful in accomplishment of these purposes.

Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited duration.
4.2. The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy

or any similar event affecting one or several shareholders.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.
5.1 The Company’s share capital is set at twenty thousand United States Dollars (USD 20,000.-), represented by twenty

thousand (20,000) shares in registered form, having a par value of one United States Dollar (USD 1.-) each, all subscribed
and fully paid-up.

5.2 The share capital may be increased or decreased in one or several times by a resolution of the shareholders, acting

in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

Art. 6. Shares.
6.1 The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
6.2 Shares are freely transferable among shareholders.
Where the Company has a sole shareholder, shares are freely transferable to third parties.
Where the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to

the prior approval of the shareholders representing at least three-quarters of the share capital.

A share transfer is only binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the

Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

6.3 A register of shareholders is kept at the registered office and may be examined by each shareholder upon request.
6.4 The Company may redeem its own shares provided that the Company has sufficient distributable reserves for that

purpose or if the redemption results from a reduction of the Company’s share capital.

III. Management - Representation

Art. 7. Appointment and removal of managers.
7.1 The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which sets the

term of their office. The managers need not be shareholders.

7.2 The managers may be removed at any time (with or without cause) by a resolution of the shareholders.

Art. 8. Board of managers. If several managers are appointed, they constitute the board of managers (the Board)

composed of one (1) or several class A managers (the Class A Managers and individually, a Class A Manager) and one (1)
or several class B managers (the Class B Managers and individually, a Class B Manager).

8.1 Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of

the Board, who has all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the corporate object.

(ii) Special and limited powers may be delegated for specific matters to one or more agents by the Board.
8.2 Procedure
(i) The Board meets upon the request of any two (2) managers, at the place indicated in the convening notice which,

in principle, is in Luxembourg.

(ii) Written notice of any meeting of the Board is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance,

except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.

(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and if they state to have full knowledge

of the agenda of the meeting. Notice of a meeting may also be waived by a manager, either before or after a meeting.
Separate written notices are not required for meetings that are held at times and places indicated in a schedule previously
adopted by the Board.

(iv) A manager may grant a power of attorney to another manager in order to be represented at any meeting of the

Board.

(v) The Board can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented provided that

there is at least one (1) Class A Manager and at least one (1) Class B Manager present or represented. Resolutions of
the Board are validly taken by a majority of the votes of the managers present or represented provided that any resolution
shall not validly be passed unless it is approved by at least one (1) Class A Manager and at least one (1) Class B Manager.
The resolutions of the Board are recorded in minutes signed by the chairman of the meeting or, if no chairman has been
appointed, by all the managers present or represented.

175891

L

U X E M B O U R G

(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference or by any other means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. The
participation by these means is deemed equivalent to a participation in person at a meeting duly convened and held.

(vii) Circular resolutions signed by all the managers (the Managers Circular Resolutions), are valid and binding as if

passed at a Board meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.

8.3 Representation
(i) The Company is bound towards third parties in all matters by the joint signature of one (1) Class A Manager and

one (1) Class B Manager.

(ii) The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have

been delegated by the Board or by one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager acting jointly.

Art. 9. Sole manager.
9.1 If the Company is managed by a sole manager, any reference in the Articles to the Board or the managers is to be

read as a reference to such sole manager, as appropriate.

9.2 The Company is bound towards third parties by the signature of the sole manager.
9.3 The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have

been delegated.

Art. 10. Liability of the managers. The managers may not, by reason of their mandate, be held personally liable for any

commitments validly made by them in the name of the Company, provided such commitments comply with the Articles
and the Law.

IV. Shareholder(s)

Art. 11. General meetings of shareholders and shareholders circular resolutions.
11.1. Powers and voting rights
(i) Resolutions of the shareholders are adopted at a general meeting of shareholders (the General Meeting).
(ii) If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular

resolution (the Shareholders Circular Resolutions), the text of which shall be sent to all the shareholders in writing,
whether in original or by telegram, telex, facsimile or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the circular
resolution.

(iii) Each share entitles to one (1) vote.
11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing at the initiative of any manager or,

failing which, shareholders representing more than one-half of the share capital.

(ii) Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight (8) days in advance of the date of

the meeting, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.

(iii) General Meetings are held at such place and time specified in the notices.
(iv) If all the shareholders are present or represented and consider themselves as duly convened and informed of the

agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice.

(v) A shareholder may grant a written power of attorney to another person, whether or not a shareholder, in order

to be represented at any General Meeting.

(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders Circular Resolutions are passed by

shareholders owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting
or first written consultation, the shareholders are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted
a second time and the resolutions are adopted at the General Meeting or by Shareholders Circular Resolutions by a
majority of the votes cast, regardless of the proportion of the share capital represented.

(vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-

quarters of the share capital.

(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase of a shareholder’s commitment in the Company

require the unanimous consent of the shareholders.

Art. 12. Sole shareholder.
12.1. Where the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers conferred

by the Law to the General Meeting.

12.2. Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders Circular Reso-

lutions is to be read as a reference to such sole shareholder or the resolutions of the latter, as appropriate.

12.3. The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.

175892

L

U X E M B O U R G

V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision

Art. 13. Financial year and approval of annual accounts.
13.1 The financial year begins on the first (1 

st

 ) of January and ends on the thirty-first (31 

st

 ) of December of each

year.

13.2 Each year, the Board prepares the balance sheet and the profit and loss account, as well as an inventory indicating

the value of the Company’s assets and liabilities, with an annex summarizing the Company’s commitments and the debts
of the manager(s) and shareholders towards the Company.

13.3 Each shareholder may inspect the inventory and the balance sheet at the registered office.
13.4 The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Share-

holders Circular Resolutions within six (6) months from the closing of the financial year.

Art. 14. Réviseurs d’entreprises.
14.1 The operations of the Company are supervised by one or several commissaires aux comptes or réviseurs d’en-

treprises agréés, when so required by the Law.

14.2 The shareholders appoint the commissaires aux comptes or réviseurs d’entreprises, if any, and determine their

number, remuneration and the term of their office, which may not exceed six (6) years. The commissaires aux comptes
or réviseurs d’entreprises may be re-appointed.

Art. 15. Allocation of profits.
15.1 The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation

and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated
to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

15.2 The General Meeting has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate such profit

to the payment of a dividend or transfer it to a reserve or carry it forward.

15.3 Interim dividends may be authorized and distributed, at any time, by the Board under the following conditions:
(i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the Board;
(ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient funds are available for distribution; it being

understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year,
increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to the statutory reserve; and

(iii) assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16.
16.1. The Company may be dissolved at any time, by a resolution of the shareholders, adopted with the consent of a

majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders appoint one
or several liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation and determine their number, powers
and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators have the broadest powers to realize
the assets and pay the liabilities of the Company.

16.2. The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be

paid to the shareholder or, in the case of a plurality of shareholders, the shareholders, in proportion to the shares held
by each shareholder in the Company.

VII. General provisions

Art. 17.
17.1 Notices and communications are made or waived and the Managers Circular Resolutions as well as the Share-

holders Circular Resolutions are evidenced in writing, by telegram, telefax, e-mail or any other means of electronic
communication.

17.2 Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with the

meetings of the Board may also be granted by a manager in accordance with such conditions as may be accepted by the
Board.

17.3 Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfill all legal requirements to be deemed

equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers Circular Resolutions, the resolutions adopted by the
Board by telephone or video conference and the Shareholders Circular Resolutions are affixed on one original or on
several counterparts of the same document, all of which taken together constitute one and the same document.

17.4 All matters not expressly governed by the Articles are determined in accordance with the law and, subject to

any non-waivable provisions of the law, any agreement entered into by the shareholders from time to time.

175893

L

U X E M B O U R G

<i>Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2015.

<i>Subscription - Payment

Thereupon Aviston, prenamed and represented as stated above, declared to subscribe to ten thousand (10,000.-)

shares in registered form with a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each, and to fully pay them up by
way of a contribution in cash amounting to ten thousand United States Dollars (USD 10,000.-) and Vertex, prenamed
and represented as stated above, declared to subscribe to ten thousand (10,000.-) shares in registered form with a nominal
value of one United States Dollar (USD 1.-) each, and to fully pay them up by way of a contribution in cash amounting to
ten thousand United States Dollars (USD 10,000.-).

The amount of twenty thousand United States Dollars (USD 20,000.-) is at the disposal of the Company, as has been

proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its incorporation are estimated at approximately one thousand four hundred Euros (1,400.- EUR).

<i>Resolutions of the Shareholders

Immediately after the incorporation of the Company, the Shareholders, representing the entirety of the subscribed

share capital have passed the following resolutions:

1. The following persons are appointed as class A managers of the Company for an indefinite period:
1) Maria Helena LOREIRO MASI UZUM, company manager, born in São Paulo, Brazil, on May 26, 1958, having her

address at Rua Canario 80, Noema, São Paulo 04521-000, Brazil;

2) William HADDAD UZUM, company manager, born in São Paulo, Brazil, on October 18, 1959, having his address

at Rua Canario 80, Noema, São Paulo 04521-000, Brazil;

3) Patricia MASI UZUM, company manager, born in São Paulo, Brazil, on February 25, 1988, having her address at Rua

Diogo Jacome 554, São Paulo 04512-001, Brazil; and

4) Arthur MASI UZUM, company manager, born in São Paulo, Brazil, on July 25, 1986, having his address at Rua Diogo

Jacome 954, São Paulo, 04512-001, Brazil.

2. The following persons are appointed as class B managers of the Company for an indefinite period:
1) Mark VRIJHOEF, company manager, born in September 12, 1974 in Zaanstad, the Netherlands, having his profes-

sional address at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg;

2) Etienne BIREN, company manager, born in September 28, 1987 in Messancy, Belgium, having his professional address

at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg;

3) Joel CARDENAS SAN MARTIN, company manager, born in March 3, 1978 in Bilbao, Spain, having his professional

address at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg;

4) Mariana VERISSIMO, company manager, born in February 25, 1979 in Martires Lisbon, Portugal, having her profes-

sional address at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg; and

5) Emanuele GRIPPO, company manager, born on 3 September 1971 in Bassano del Grappa, Italy, having his profes-

sional address at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

3. The registered office of the Company is set at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy-holder, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatorze, le dix-septième jour du mois d’octobre,
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

ONT COMPARU:

Aviston Financial Corp., une société constituée selon les lois des Iles Vierges Britanniques ayant son adresse au c/o

Aleman, Cordero, Galindo &amp; Lee Trust (BVI) Limited, P.O. Box 3175, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques and
enregistrée sous le numéro 460342 (Aviston),

ici représentée par Régis Galiotto, clerc de notaire, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, Grand-Duché

de Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé; et

175894

L

U X E M B O U R G

Vertex Financial Holdings, Ltd., une société limitée constituée selon les lois des Iles Vierges Britanniques ayant son

adresse au Marcy Building, 2 

nd

 floor, Purcell Estate, P.O. Box 2416, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques and

enregistrée sous le numéro 1778490 (Vertex, et ensemble avec Aviston, les Associés),

ici représentée par Régis Galiotto, clerc de notaire, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, Grand-Duché

de Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et

le notaire instrumentant, annexées au présent acte pour les formalités de l’enregistrement.

Les parties comparantes, représentées comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte

d’une société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée

Art. 1 

er

 . Dénomination.  Le nom de la société est «Kaloo S.à r.l.» (la Société). La Société est une société à responsabilité

limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).

Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans la

commune de Luxembourg par décision du conseil de gérance. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit
du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés, selon
les modalités requises pour la modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l’étranger

par décision du gérant unique ou, le cas échéant, du conseil de gérance. Lorsque le gérant unique ou le conseil de gérance
estime que des développements ou événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont
imminents, et que ces développements ou évènements sont de nature à compromettre les activités normales de la Société
à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l’étranger, le siège social peut être transféré provi-
soirement à l’étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances extraordinaires Ces mesures provisoires n'ont
aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son siège social, reste une société
luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social.
3.1. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembour-

geoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre manière
ainsi que l’aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la gestion,
le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

3.2. Un objet supplémentaire de la Société est l’acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-Duché de

Luxembourg soit à l’étranger ainsi que toutes les opérations liées à des biens immobiliers, comprenant la prise de parti-
cipations directes ou indirectes dans des sociétés au Luxembourg ou à l’étranger dont l’objet principal consiste dans
l’acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers.

3.3. La Société peut également garantir, accorder des sûretés à des tiers afin de garantir ses obligations ou les obligations

de sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même
groupe de sociétés que la Société, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient
une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société ou à
des tiers.

3.4. La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle, financière ou de propriété intel-

lectuelle estimées utiles pour l’accomplissement de ces objets.

Art. 4. Durée.
4.1 La Société est constituée pour une durée indéterminée.
4.2 La Société n'est pas dissoute en raison du décès, de la suspension des droits civils, de l’incapacité, de l’insolvabilité,

de la faillite ou de tout autre évènement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social de la Société est fixé à vingt mille dollars américains (USD 20.000,-) représenté par vingt mille

(20.000,-) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale d’un dollar américain (USD 1,-) chacune, toutes
souscrites et entièrement libérées.

5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de

l’associé unique ou, le cas échéant, de l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification
des Statuts.

175895

L

U X E M B O U R G

Art. 6. Parts sociales.
6.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu’un (1) seul propriétaire par part sociale.
6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.
Lorsque la Société a plus d’un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l’accord

préalable des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.

Une cession de parts sociales n’est opposable à l’égard de la Société ou des tiers, qu’après avoir été notifiée à la Société

ou acceptée par celle-ci conformément à l’article 1690 du Code Civil.

6.3. Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.
6.4. La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition que la Société ait des réserves distribuables suffi-

santes à cet effet ou que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.

III. Gestion - Représentation

Art. 6. Nomination et révocation des gérants.
6.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur

mandat. Les gérants ne doivent pas nécessairement être associés

6.2 Les gérants sont révocables à tout moment (avec ou sans raison) par une décision des associés.

Art. 7. Conseil de gérance. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent le conseil de gérance (le Conseil), composé

d'un (1) ou plusieurs gérants de classe A (les Gérants de Classe A et individuellement, le Gérant de Classe A) et un (1)
ou plusieurs gérants de classe B (les Gérants de Classe B et individuellement, le Gérant de Classe B).

8.1. Pouvoirs du conseil de gérance
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à ou aux associés sont de la compétence du

Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l’objet social.

(ii) Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches

spécifiques.

8.2. Procédure
(i) Le Conseil se réunit sur convocation de deux (2) gérants au lieu indiqué dans l’avis de convocation, qui en principe,

est au Luxembourg.

(ii) Il est donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24)

heures à l’avance, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées dans
la convocation à la réunion.

(iii) Aucune convocation n’est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et s’ils déclarent

avoir parfaitement eu connaissance de l’ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation
à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des
réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.
(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés

et au moins un (1) Gérant de Classe A et un (1) Gérant de Classe B sont présents ou représentés. Les décisions du
Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés pourvu que toute résolution
ne soit valablement adoptée que si elle est approuvée par au moins un (1) Gérant de Classe A et un (1) Gérant de Classe
B. Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun
président n'a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés

(vi) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visio-conférence ou par tout autre moyen

de communication permettant à l’ensemble des personnes participant à la réunion de s’identifier, de s’entendre et de se
parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement con-
voquée et tenue.

(vii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (les Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et

engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d’une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue
et portent la date de la dernière signature.

8.3. Représentation
(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par les signatures conjointes d'un (1) Gérant de

Classe A et un (1) Gérant de Classe B.

(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux

ont été délégués par le Conseil ou par un (1) Gérant de Classe A et un (1) Gérant de Classe B agissant conjointement.

Art. 9. Gérant unique.
9.1. Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux gérants doit être

considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.

175896

L

U X E M B O U R G

9.2. La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature du gérant unique.
9.3. La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux

ont été délégués.

Art. 10. Responsabilité des gérants.
10.1. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle concernant les engagements

régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont conformes aux Statuts et à la
Loi.

IV. Associé(s)

Art. 11. Assemblées générales des associés et résolutions circulaires des associés.
11.1. Pouvoirs et droits de vote
(i) Les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés (l’Assemblée Générale).
(ii) S’il n’y a pas plus de vingt-cinq associés, les décisions des associés peuvent être prises par voie de résolutions

circulaires (les Résolutions Circulaires des Associés), dont le texte est communiqué à l’écrit à tous les associés, soit en
original ou soit par télégramme, télex, facsimilé ou e-mail. Les associés expriment leur vote en signant les résolutions
circulaires.

(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
11.2. Convocations, quorum, majorité et procédures de vote
(i) Les associés sont convoqués aux Assemblées Générales ou consultés par écrit à l’initiative de tout gérant ou, à

défaut, des associés représentant plus de la moitié du capital social.

(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant

la date de l’assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées
dans la convocation à l’assemblée.

(iii) Les Assemblées Générales sont tenues au lieu et heure indiqués dans les convocations.
(iv) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été dûment convoqués et informés

de l’ordre du jour de l’assemblée, l’Assemblée Générale peut être tenue sans convocation préalable.

(v) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à

toute Assemblée Générale.

(vi) Les décisions à adopter en Assemblées Générales ou par Résolutions Circulaires des Associés sont adoptées par

des associés détenant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée
Générale ou première consultation écrite, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée
Générale ou consultés une seconde fois, et les décisions sont adoptées par l’Assemblée Générale ou par Résolutions
Circulaires des Associés à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.

(vii) Les Statuts sont modifiés avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les

trois-quarts du capital social.

(viii) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l’engagement d'un associé dans la

Société exige le consentement unanime des associés.

Art. 12. Associé unique.
12.1. Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1), l’associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par

la Loi à l’Assemblée Générale.

12.2. Toute référence dans les Statuts aux associés et à l’Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des

Associés doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à cet associé unique ou aux résolutions de ce dernier.

12.3. Les résolutions de l’associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle

Art. 13. Exercice social et approbation des comptes annuels.

13.1. L'exercice social commence le premier (1 

er

 ) janvier et se termine le trente-et-un (31) décembre de chaque

année.

13.2. Chaque année, le Conseil dresse le bilan et le compte de résultat, ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur des

actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes du ou des
gérants et des associés envers la Société.

13.3. Chaque associé peut prendre connaissance de l’inventaire et du bilan au siège social.
13.4. Le bilan et le compte de résultat sont approuvés par l’Assemblée Générale annuelle ou par Résolutions Circulaires

des Associés dans les six (6) mois suivant la clôture de l’exercice social.

175897

L

U X E M B O U R G

Art. 14. Réviseurs d'entreprises.
14.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs commissaires aux comptes ou réviseurs d'en-

treprises, dans les cas prévus par la loi.

14.2. Les associés nomment les commissaires aux comptes ou les réviseurs d'entreprises, le cas échéant, et déterminent

leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat, lequel ne peut dépasser six (6) ans. Les commissaires aux
comptes ou réviseurs d'entreprises sont rééligibles.

Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements

et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société qui sera
affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

15.2. L'assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l’affectation du solde restant du bénéfice net

annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l’affecter à la réserve ou le reporter.

15.3. Des dividendes intérimaires pourront être autorisés et distribués à tout moment par le Conseil dans les conditions

suivantes:

(i) un état comptable ou un inventaire ou un rapport est dressé par le Conseil;
(ii) il ressort de cet état comptable, inventaire ou rapport que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution,

étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à allouer
à la réserve légale; et

(iii) il est établi que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16.
16.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la majorité (en nombre)

des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social. Les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs,
associés ou non, pour réaliser la liquidation et déterminent leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf décision contraire
des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer les dettes de la
Société.

16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué

à  l’associé  unique,  ou  en  cas  de  pluralité  d'associés,  aux  associés,  proportionnellement  au  nombre  de  parts  sociales
détenues par chacun d'eux dans la Société.

VII. Dispositions générales

Art. 17.
17.1. Les convocations et communications, respectivement les renonciations à celles-ci, sont faites, et les Résolutions

Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Circulaires des Associés sont établies par écrit, télégramme, fax, e-mail
ou tout autre moyen de communication électronique.

17.2. Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du

Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.

17.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire à l’ensemble des

conditions légales pour pouvoir être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires
des Gérants, des résolutions adoptées par le Conseil par téléphone ou visioconférence et des Résolutions Circulaires
des Associés, selon le cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble,
constituent un seul et même document.

17.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des

dispositions légales d'ordre public, à tout accord conclu de temps à autre entre les associés.

<i>Disposition transitoire

La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2015.

<i>Souscription - Libération

Ces faits exposés, Viston, prénommée et représentée comme décrit ci-dessus, déclare souscrire dix mille (10.000,-)

parts sociales sous forme nominative avec une valeur nominale d’un dollar américain (USD 1.-) chacune, et les libérer
entièrement par versement en espèces de dix mille dollars américains (USD 10.000,-) et, Vertex, prénommée et repré-
sentée comme décrit ci-dessus, déclare souscrire dix mille (10.000,-) parts sociales sous forme nominative avec une valeur
nominale d’un dollar américain (USD 1.-) chacune, et les libérer entièrement par versement en espèces de dix mille dollars
américains (USD 10.000,-);

La somme de vingt mille dollars américains (USD 20.000,-) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au

notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

175898

L

U X E M B O U R G

<i>Coûts

Les parties comparantes ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille quatre cents
Euros (1.400.- EUR).

<i>Décisions des Associés

Et aussitôt, les Associés, représentant l’intégralité du capital social ont pris les résolutions suivantes:
1. Les personnes suivantes sont nommées comme gérants de classe A de la Société pour une durée indéterminée:
1) Maria Helena LOREIRO MASI UZUM, gérante de sociétés, née à São Paulo, Brésil, le 26 mai 1958, ayant son adresse

au Rua Canario 80, Noema, São Paulo 04521-000, Brésil;

2) William HADDAD UZUM, gérant de sociétés, né à São Paulo, Brésil, le 18 octobre 1959 ayant son adresse au Rua

Canario 80, Noema, São Paulo 04521-000, Brésil;

3) Patricia MASI UZUM, gérante de sociétés, née à São Paulo, Brésil, le 25 février 1988, ayant son adresse au Rua

Diogo Jacome 554, São Paulo 04512-001, Brésil; et

4) Arthur MASI UZUM, gérant de sociétés, né à São Paulo, Brésil, le 25 juillet 1986, ayant son adresse au Rua Diogo

Jacome 954, São Paulo, 04512-001, Brésil.

2. Les personnes suivantes sont nommées comme gérants de classe B de la Société pour une durée indéterminée:
1) Mark VRIJHOEF, gérant de sociétés, né le 12 septembre à Zaanstad, Pays Bas, ayant son adresse professionnelle au

6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg;

2) Etienne BIREN, gérant de sociétés, né le 28 septembre 1987 à Messancy, Belgique, ayant son adresse professionnelle

au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg;

3) Joel CARDENAS SAN MARTIN, gérant de sociétés, né le 3 mars 1978 à Bilbao, Espagne, ayant son adresse pro-

fessionnelle au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg;

4) Mariana VERISSIMO, gérante de sociétés, née le 25 février 1979 à Martires Lisbonne, Portugal, ayant son adresse

professionnelle au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg; et

5) Emanuele GRIPPO, gérant de sociétés, né le 3 septembre 1971 à Bassano del Grappa, Italie, ayant son adresse

professionnelle au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

3. Le siège social de la Société est établi au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande des parties comparantes, le présent

acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte
français, le texte anglais fera foi.

Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 octobre 2014. Relation: LAC/2014/49798. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 10 novembre 2014.

Référence de publication: 2014174674/523.
(140200183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2014.

H'Corp, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 24, rue Astrid.

R.C.S. Luxembourg B 150.191.

Le Bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 novembre 2014.

<i>Pour H'Corp S.à r.l.
Fiduciary Tucci &amp; Partners SA

Référence de publication: 2014174611/12.
(140199547) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2014.

175899

L

U X E M B O U R G

Lux 48 Starlight GBP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 13.000,00.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.

R.C.S. Luxembourg B 191.661.

STATUTES

In the year two thousand and fourteen, on the third day of the month of November.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Starwood Capital Operations, LLC, a LLC organized under the laws of the State of Delaware, having its registered

office at Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, in the City of Wilmington, County of New Castle, registered
with the State of Delaware under number 2975092,

here represented by Mister Gianpiero SADDI, private employee, residing professionally at 74, Avenue Victor Hugo,

L-1750 Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal in Luxembourg.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the representative of the appearing party and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated here-above, requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name

“Lux 48 Starlight GBP S.à r.l.” (the “Company”), which shall be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the
law dated August 10, 1915 on commercial companies as amended (the “Company Law”) and by the present articles of
association (the “Articles”).

Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg City.
2.2 The registered office of the Company may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution

of the Company’s board of managers. The registered office may further be transferred to any other place within the
Grand Duchy of Luxembourg by a resolution adopted by the shareholders in the manner required to amend the Articles.

2.3. Branches, subsidiaries or other offices may be established either within the Grand Duchy of Luxembourg or abroad

by a resolution of the board of managers. Where the board of managers determines that extraordinary political or military
developments or events have occurred or are imminent as determined in the sole discretion of the board of managers
and that these developments or events may interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall
have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office,
shall remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Object. The Company’s purpose is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any com-

mercial, industrial, financial and other, Luxembourg or foreign enterprises. The Company’s purpose is, in particular, to
generate significant returns for its shareholders by

(i) locating, analyzing, investing in, acquiring, holding, originating, maintaining, operating, leasing, managing, developing,

improving, mortgaging, encumbering, and selling for profit equity and debt interests in real estate and in securities and
other interests related to real estate, including, without limitation, developable land, rental apartment buildings, office
properties, retail properties, industrial properties, research and development properties, hotels, resorts and destination
complexes, timeshares, motels and other lodging facilities, mixed use properties, telco properties and zoned residential
land and debt instruments secured by real estate or by interests in such real estate,

(ii) participating as a partner, owner or investor in or lender to other general or limited partnerships, limited liability

companies, corporations or other vehicles or Persons, the business of which is related to real estate including, without
limitation, the ownership, sale, leasing, financing, development and/or management thereof or the provision of services
thereto, and

(iii) engaging in all other activities related or incidental thereto.
The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all

areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 4. Duration.
4.1 The Company is formed for an unlimited duration.

175900

L

U X E M B O U R G

4.2 The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the shareholders of the Company adopted in the

manner required to amend the Articles.

4.3  The  Company  shall  not  be  dissolved  by  reason  of  the  death,  suspension  of  civil  rights,  incapacity,  insolvency,

bankruptcy or any similar event affecting one or several of the shareholders.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.
5.1. The Company's corporate capital is set at thirteen thousand British Pounds (GBP 13,000) represented by five

hundred (500) shares in registered form with a nominal value of twenty-six British Pounds (GBP 26), all subscribed and
fully paid-up.

5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the

shareholders, adopted in the manner required to amend the Articles.

5.3 Any share premium paid in respect of any shares upon their issuance shall be allocated to a share premium account

of the Company. Such share premium account (“the share premium account”) may be incorporated into the share capital
of the Company, against the issuance of new shares, subject to the provisions of the Articles. Moreover, the amount of
the said share premium account may be used to provide for the payment of shares, which the Company may redeem
from its respective shareholders, to offset any net losses, to make distributions to the shareholders, or to allocate funds
to the legal reserve.

Art. 6. Shares.
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion

to the number of shares in existence.

6.2. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is recognized per share. Joint

owners must appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.3. Shares are freely transferable among shareholders. The transfer of shares (inter vivos) to non-shareholders is

subject to the prior approval of the general meeting of shareholders representing at least three quarters (3/4) of the share
capital of the Company. A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following notification
to, or acceptance by, the Company in accordance with article 1690 of the civil code. For all other matters, reference is
made to articles 189 and 190 of the Company Law.

6.4. A shareholders’ register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions

of the Company Law and may be examined by any shareholder who so requests.

6.5. The Company may redeem its own shares, in the framework of a decrease of its share capital by cancellation of

the redeemed shares, under the following terms and conditions:

(i) the redemption price shall be set by reference to the nominal value of each redeemed share, or if higher within the

total amount of any distributable sums in accordance with the entitlement of the redeemed shares as provided for by the
Articles. Where the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption
may only be decided to the extent that sufficient distributable sums are available as regards the excess purchase price;

(ii) the redemption shall be carried out by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders, representing

at least seventy-five percent (75%) of the share capital; and

(iii) the redeemed shares shall be cancelled following the decrease of the capital.

III. Management - Representation

Art. 7. Manager(s).
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by the shareholders who set the term of their

office. Managers of the Company need not be shareholders.

7.2 If several managers have been appointed, they shall collectively constitute a board of managers.
7.3 If a sole manager has been appointed, she/he/it shall assume all powers conferred by the Company Law and the

Articles to the board of managers. The sole manager shall have the option of memorializing her/his/its decisions in minutes.

7.4. The managers are eligible for reappointment but may be dismissed at any time ad nutum (i.e. without any reason)

by a resolution of the shareholders. A Manager may resign at any time, but a resigning Manager shall continue to hold
office until his successor has been appointed.

Art. 8. Powers.
8.1. All powers not expressly reserved by the Luxembourg law or the present Articles to the shareholders fall within

the competence of the board of managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company’s object.

8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, whether shareholders

or not, by the board of managers or in accordance with article 10.

175901

L

U X E M B O U R G

Art. 9. Procedure.
9.1 The board of managers may appoint from among its members a chairman, who will preside at all meetings of the

board of managers and of the shareholders. It may also appoint a secretary, who need not be a manager and who will be
responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the shareholders.

9.2 The board of managers shall meet as often as the Company’s interests so require or upon call of the chairman or

any other manager at the place indicated in the convening notice.

9.3 Written notice of any meeting of the board of managers, regardless of whether such notice is the original or a

copy delivered by telegram, telex, facsimile or e-mail, shall be given to all managers at least twenty-four (24) hours in
advance of the date set for such meeting, except in the case of an emergency meeting, in which case the nature of such
circumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.

9.4 No such convening notice is required if all members of the board of managers are present or represented at the

meeting and if they state to have been duly informed and to have had full knowledge of the agenda of the meeting. The
notice requirement may be waived by the written consent, regardless of whether the original consent or a copy thereof
is delivered by telegram, telex, facsimile or e-mail, of each member of the board of managers. Separate written notice
shall not be required for meetings that are held at times and places designated in a schedule previously adopted by a
resolution of the board of managers.

9.5 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing, regardless of whether the

original appointment or a copy thereof delivered by telegram, telex, facsimile or e-mail, another manager as his proxy. A
manager may also appoint another manager as his proxy by phone, such appointment to be confirmed subsequently in
writing.

9.6 The board of managers may validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.

Resolutions of the board of managers are validly taken by a majority of the votes cast. The resolutions of the board of
managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.

9.7 Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or

by any other similar means of communication that allows all the persons taking part in the meeting to identify, hear and
speak to each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to in-person participation at
such meeting.

9.8 Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting

duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution
and may be evidenced by an original or by a copy delivered by telegram, telex, facsimile or e-mail.

Art. 10. Representation of the Company.
10.1 The Company shall be bound towards third parties by the sole signature of its single manager, and, in case of

plurality of managers, by the single signature of any member of the board or managers or by the joint or single signature
of any person to whom such signatory power shall have been delegated by the board of managers.

10.2 The Company shall furthermore be bound towards third parties by the single or joint signature of any persons

to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with article 8.2 and within the limits of such
power.

Art. 11. Conflicts of interest.
11.1 In the event that any manager or officer of the Company may have any personal interest in any transaction of the

Company, such manager or officer shall make known to the board of managers such personal interest and shall not
consider or vote upon any such transaction, and such transaction, and such manager’s or officer’s interest therein, shall
be reported to the next succeeding meeting of the shareholders.

11.2 Notwithstanding the above, no contract or other transaction between the Company and any other company or

firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the managers or officers of the Company is
interested in, or is a manager, director, associate, officer or employee of such other company or firm. Any manager or
officer of the Company who serves as a director, officer or employee of any company or firm with which the Company
shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm,
be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Art. 12. Liability of the managers.
12.1 In connection with their mandate, the managers assume no personal liability for any commitment validly made by

them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles and the applicable
provisions of the Luxembourg law.

12.2 To the extent permissible under Luxembourg law and except as provided for in article 59 paragraph 2 of the

Company Law, a manager shall not be responsible for the acts, omissions or defaults of the other managers, or for any
loss or damage caused by an error of judgment or oversight on their part, or for any other loss, damage or misfortune
whatsoever which may occur in the performance of their duties, except if the same is caused by his gross negligence or
willful default.

175902

L

U X E M B O U R G

12.3 To the full extent permissible under Luxembourg law, the managers and other officers of the Company, as well

as those persons to whom signatory powers have been validly delegated in accordance with article 8.2, shall be indemnified
out of the assets of the Company for all costs, charges, losses, damages and expenses incurred or sustained by them in
connection with any actions, claims, suits or proceedings to which they may be made a party by reason of being or having
been managers, officers or delegates of the Company, by reason of any transaction carried out by the Company, any
contract entered into or any action performed, concurred in, or omitted, in connection with the execution of their duties,
save for liabilities and expenses caused by from their gross negligence or willful default and in each case without prejudice
to any other rights to which such persons may be entitled.

IV. General Meetings of shareholders

Art. 13. Powers and voting rights.
13.1 The general meeting of shareholders properly constituted represents the entire body of shareholders of the

Company. It has the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to all operations of the Company within
the limits of the Company Law.

13.2 Each share is entitled to one vote. Each shareholder has voting rights commensurate to his shareholding.
13.3 Without prejudice to articles 13.4 and 13.5, resolutions of the shareholders shall be adopted at general meetings.
13.4 If there are not more than twenty-five (25) shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by

circular resolution. The shareholders shall be consulted in writing in accordance with article 14.2 and shall cast their vote
by signing the circular resolution. Shareholders shall be obliged to cast their vote and mail it to the Company within fifteen
(15) days as from the sending of the text of the proposed resolution. The signatures of the shareholders may appear on
a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by an original or by a copy
delivered by telegram, telex, facsimile or e-mail.

13.5 The sole shareholder assumes all powers conferred by the Company Law to the general meeting of shareholders.

The decisions of the sole shareholder shall be memorialized in minutes.

Art. 14. Notices, quorum, majority and voting proceedings.
14.1 The shareholders may be convened or consulted by any manager. The board of managers must convene or consult

the shareholders at the request of shareholders representing more than one-half (1/2) of the share capital of the Company.

14.2 The shareholders shall be convened or consulted in writing, whether in original or delivered by telegram, telex,

facsimile or e-mail.

14.3 Written notice of any meeting of the shareholders shall be given to all shareholders at least eight (8) days in

advance of the date set for such meeting, except in case of an emergency, in which case the nature of such circumstances
shall be set forth in the convening notice of the meeting.

14.4 Meetings of the shareholders of the Company shall be held at such place and time as may be specified in the

convening notices for the meetings.

14.5  If  all  the  shareholders  of  the  Company  are  present  or  represented  at  a  meeting  of  the  shareholders  of  the

Company, and consider themselves as having been duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting
may be held without prior notice.

14.6 A shareholder may act at any meeting of the shareholders of the Company by appointing another person (who

need not be a shareholder) as his proxy, such proxy to be granted in writing, whether in original or delivered by telegram,
telex, facsimile or e-mail.

14.7 Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than one-

half (1/2) of the share capital of the Company. If this figure is not reached at the first meeting or upon the first written
consultation, the shareholders shall be convened or consulted a second time by registered letter, and decisions shall be
adopted by a majority of the votes cast, regardless of the proportion of the share capital represented.

14.8 However, resolutions to modify or amend the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be

adopted by the majority of the shareholders owning at least three (3/4) quarters of the share capital of the Company.
However, under no circumstances may a majority of the shareholders oblige any shareholders to increase their partici-
pation in the Company.

14.9 The shareholders may only change the nationality of the Company by unanimous vote.

V. Annual accounts - Allocation of profits

Art. 15. Accounting Year and annual general meeting.
15.1 The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first of

December of the same year.

15.2 Each year, with reference to the end of the Company’s accounting year, the Company’s board of managers shall

prepare the balance sheet and the profit and loss accounts of the Company as well as an inventory including the value of
the Company’s assets and liabilities, with an annex summarizing all of the Company’s commitments and the debts of the
manager(s), auditor(s) and shareholders of the Company.

175903

L

U X E M B O U R G

15.3 Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
15.4 If there are more than twenty-five (25) shareholders, the annual general meeting of the shareholders shall be held

at the registered office of the Company or at such other place within the municipality of the registered office as may be
specified in the convening notice.

15.5 If there are not more than twenty-five (25) shareholders, the annual general meeting of the shareholders shall be

held at such place and time as may be specified in the convening notice for the meeting, such meeting to take place within
the time period set forth by the Company Law.

Art. 16. Allocation of Profits.
16.1 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve as required by

the Company Law. This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve is equal to ten per cent (10%)
of the share capital of the Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in article 5.

16.2 The general meeting of shareholders has discretionary power to allocate any surplus. It may in particular allocate

such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.

16.3 Interim dividends may be distributed, at any time, pursuant to the following conditions:
(i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the board of managers;
(ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient profits and other reserves (including share

premium) are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits
accrued since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves and de-
creased by carried forward losses and sums to be allocated to the statutory reserve;

(iii) the decision to pay interim dividends is taken by the shareholders of the Company;
(iv) assurance has been given that the rights of the creditors of the Company are not threatened; and
(v) if after the close of the financial year, the amount available for distribution is less than the amount distributed as

an interim dividend, the relevant shareholders shall be required to refund the shortfall to the Company.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 17. Dissolution, Liquidation.
17.1 In the event of the dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

who need not be shareholders, appointed by a resolution of the general meeting of shareholders which will determine
their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the shareholders or by the Company
Law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the sale of the assets and the payment of the liabilities
of the Company.

17.2 Any surplus remaining from the sale of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be paid

to the shareholders in proportion to the shares held by each shareholder of the Company.

VII. General provision

Art. 18. General provision. Reference is made to the provisions of the Company Law and to any agreement which

may be entered into among the shareholders from time to time (if any) for all matters for which no specific provision is
made in these Articles.

<i>Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on December 31, 2014.

<i>Subscription - Payment

All the 500 (five hundred) shares representing the capital have been entirely subscribed by Starwood Capital Opera-

tions, LLC prenamed, and fully paid up in cash, therefore the amount of thirteen thousand British Pounds (13,000 GBP)
is as now at the disposal of the Company proof of which has been duly given to the notary.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its incorporation are estimated at approximately one thousand four hundred euro (EUR 1,400).

The amount of GBP 13,000 (thirteen thousand Pound Sterling) corresponds to the amount of EUR 16,643.61 (sixteen

thousand six hundred forty-three Euro and sixty-one Eurocent) according to the exchange rate published on XE.COM
on November 3 

rd

 , 2014.

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately upon the incorporation of the Company, the sole shareholder of the Company, representing all of the

subscribed share capital, passed the following resolutions:

175904

L

U X E M B O U R G

<i>First resolution

The sole shareholder resolves to set at two (2) the number of members of the board of managers and to appoint the

following persons as the managers of the Company for an unlimited period of time:

(i) Mr. Thierry DRINKA, born in Laon (France) on October 11, 1968, with professional address at 3 rue Mozart,

L-2166 Luxembourg;

(ii) Mr. Jerome SILVEY, born in Pennsylvania (USA) on June 27, 1957, with professional address at 591, West Putnam

Avenue, Greenwich, CT 06830, United States of America; and

<i>Second resolution

The sole shareholder resolves to establish the registered office of the Company at 4, rue Dicks, L-1417 Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the proxyholder

of the above appearing party, the present deed is worded in English followed by a French translation, and in case of any
divergences between the English and the French texts, the English version shall prevail.

WHEREOF the present deed is drawn up in Luxembourg, at the office of the undersigned notary, on the date first

indicated in this document.

The present deed, having been read to the proxyholder of the appearing party, was signed by the proxyholder and

the notary.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatorze, le trois novembre,
par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

a comparu

Starwood Capital Operations LLC, une Limited Liability Company de droit de l’Etat du Delaware, ayant son siège social

au Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, dans la ville de Wilmington, Comté de New Castle, inscrite dans l’Etat
du Delaware (USA) sous le numéro 2975092,

ici représentée par Monsieur Gianpiero SADDI, employé privé, demeurant professionnellement à L-1750 Luxembourg,

74, Avenue Victor Hugo, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instru-

mentant, restera annexée au présent acte pour les formalités de l’enregistrement.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d’acter de la façon suivante

les statuts d’une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:

I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée

Art. 1 

er

 . Dénomination.  Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination «Lux 48 Starlight GBP

S.à r.l.» (la «Société»), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales telle que modifiée (la «Loi») et par les présent statuts (les «Statuts»).

Art. 2. Siège social.
2.1 Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg.
2.2 Le siège social de la Société peut être transféré dans les limites de la commune par décision du conseil de gérance.

Le siège social peut également être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution
des associés adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

2.3 Il peut être créé des succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger par

décision du conseil de gérance de la Société si le conseil de gérance estime que des événements extraordinaires d’ordre
politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces évènements seraient de nature à compromettre
l’activité normale de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l’étranger, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces
mesures provisoires n’auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert de son siège
social, restera une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social. L’ objet de la Société est de prendre des participations et des intérêts sous quelque forme que ce

soit, dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, qu’elles soient luxembour-
geoises ou étrangères.

Plus particulièrement, la Société a pour objet de générer d’importants bénéfices au profit de ses associés par
(i) La localisation, l’analyse, l’investissement, l’acquisition, la détention, l’initialisation, le soutien, le maintien, le contrôle,

la location, la gestion, le développement, l’amélioration, l’hypothèque, les sûretés et garanties, la vente bénéficiaire et la
conclusion d’emprunts porteurs d’intérêts relatifs à des propriétés immobilières ou titres et autres intérêts liés à l’im-

175905

L

U X E M B O U R G

mobilier, y inclus, sans y être limités, les terres à améliorer et développer, les immeubles de rapport et d’appartements
à louer, les immeubles de bureaux, les maisons unifamiliales, les ensembles industriels, les immeubles de recherche et
développement, les parcs de loisirs, ensembles et complexes hôteliers, les propriétés à temps partiels, motels et autres
lieux d’hébergement, habitations mixtes, propriétés telco et terrains en zone résidentielle, et les emprunts hypothécaires
ou garantis par des sûretés grevant ces droits immobiliers,

(ii) Prendre des participations en tant qu’associé, propriétaire ou investisseur ou bailleur de fonds, comme commandité

ou commanditaire de société en commandite, associé de sociétés à responsabilité limitée, actionnaire de sociétés ano-
nymes, ou autres formes juridiques de personnes morales, dont l’objet commercial est en relation avec le domaine de
l’immobilier, en ce compris, sans y être limité, la propriété, la vente, la location, le financement, le développement et/ou
la gestion de ceux-ci ou la prestation de services y relative, et

(iii) L’engagement et l’implication dans toute autre activité qui pourrait être liée à celles évoquées ci-avant, de manière

directe, indirecte ou accessoire.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte

avec les activités prédécrites aux fins de faciliter l’accomplissement de son objet.

Art. 4. Durée.
4.1 La Société est formée pour une durée indéterminée.
4.2 La Société peut être dissoute, à tout moment, par une résolution des associés de la Société adoptée selon les

modalités requises pour la modification des Statuts.

4.3 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l’interdiction, de l’incapacité, de l’insolvabilité, de la faillite

ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital social - Parts sociales

Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social de la Société est fixé à treize mille Livres Sterling (GBP 13.000) représenté par cinq cents (500)

parts sociales sous forme nominative, d’une valeur nominale de vingt-six Livres Sterling (GBP 26), toutes souscrites et
entièrement libérées.

5.2 Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par résolution des associés

adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

5.3 Toute prime d'émission payée lors de l’émission de parts sociales doit être affectée à un compte de prime d'émission

(le «Compte de Prime d'émission des Parts Sociales») de la Société. Le Compte de Prime d'émission des Parts Sociales
peut être incorporé dans le capital social de la Société, en échange respectivement de l’émission de nouvelles Parts
Sociales, conformément aux dispositions des Statuts. En outre, le Compte de Prime d'émission des Parts Sociales peut
être utilisé pour effectuer le remboursement de Parts Sociales, que la Société peut racheter aux associés respectifs, pour
compenser des pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions, respectivement, aux associés détenant des Parts
Sociales ou pour être affecté à la réserve légale.

Art. 6. Parts sociales.
6.1. Chaque part sociale donne droit à son détenteur à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion

directe avec le nombre des parts sociales existantes.

6.2. Envers la Société, les parts sociales de la Société sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale

est admis. Les copropriétaires doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.3. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. La cession de parts sociales (inter vivos) à des non

associés est soumise à l’accord préalable de l’assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts (3/4)
du capital social de la Société. Une cession de parts sociales n’est opposable à la Société ou aux tiers qu’après qu’elle a
été notifiée à la Société ou acceptée par elle en conformité avec l’article 1690 du code civil. Pour toutes les autres
questions, il est fait référence aux articles 189 et 190 de la Loi.

6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi et peut

être consulté par chaque associé qui le désire.

6.5. La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales, dans le cadre d'une réduction de son capital

souscrit par annulation des parts rachetées et conformément aux modalités et conditions suivantes:

(i) le prix de rachat est fixé par référence à la valeur nominale de chacune des parts sociales rachetées, ou, s'il est

supérieur, dans la limite du montant total de toutes les sommes distribuables et en conformité avec les droits conférés
aux parts sociales rachetées tels que prévus par les Statuts. Lorsque le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale
des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être décidé que dans la mesure où des sommes distribuables suffisantes
sont disponibles pour couvrir l’excédent de prix;

(ii) le rachat est décidé par une résolution prise par la majorité des associés représentant au moins soixante-quinze

pour cent (75%) du capital social de la Société; et

(iii) les parts sociales rachetées sont annulées immédiatement après la réduction du capital social.

175906

L

U X E M B O U R G

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Conseil de gérance.
7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par les associés, qui fixeront la durée de leur mandat. Le

ou les gérants ne sont pas nécessairement associés.

7.2 Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance.
7.3 Si un gérant unique a été nommé, il assume tous les pouvoirs conférés par la Loi et les Statuts au conseil de gérance.

Le gérant unique aura l’option de consigner ses décisions dans des procès-verbaux.

7.4 Les gérants sont rééligibles pour nomination mais révocables à n’importe quel moment ad nutum (sans justifier

d’une raison) par une résolution des associés. Un gérant peut démissionner de son mandat à n’importe quel moment
mais un gérant démissionnaire devra continuer d’exercer son mandat jusqu’à ce qu’un successeur lui soit désigné.

Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance.
8.1 Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts aux associés seront de la compé-

tence du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et activités conformes à l’objet
social de la Société.

8.2 Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, associés

ou non, par le conseil de gérance de la Société ou conformément à l’article 10.

Art. 9. Procédure.
9.1 Le conseil de gérance peut nommer parmi ses membres un président, qui présidera toutes les réunions du conseil

de gérance et des associés. Il peut aussi nommer un secrétaire, qui n’a pas besoin d’être un gérant et qui sera responsable
de garder les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et des associés.

9.2 Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige ou sur convocation d’un gérant au

lieu indiqué dans l’avis de convocation.

9.3 Il sera donné à tous les gérants une convocation, qu’elle soit en original ou en copie envoyée par télégramme,

télex, facsimile ou courriel, de toute réunion du conseil de gérance au moins vingt-quatre (24) heures avant la date prévue
pour la réunion, sauf en cas de réunion urgente, auquel cas la nature de cette urgence sera mentionnée dans la convocation
de la réunion du conseil de gérance.

9.4 Cette convocation écrite n’est pas nécessaire si tous les membres du conseil de gérance de la Société sont présents

ou représentés à la réunion et déclarent avoir été dûment informés et avoir une parfaite connaissance de l’ordre du jour
de la réunion. Il peut aussi être renoncé à l’exigence de convocation écrite avec l’accord écrit de chaque membre du
conseil de gérance que le consentement soit en original, soit en copie envoyée par télégramme, télex, facsimile ou courrier
électronique par chaque membre du conseil de gérance. Des convocations écrites séparées ne seront pas exigées pour
des réunions se tenant à une heure et à un endroit prévus dans un calendrier préalablement adopté par résolution du
conseil de gérance de la Société.

9.5 Tout gérant peut participer à toute réunion du conseil de gérance en nommant par écrit, que ce soit en original

ou sur copie par télégramme, télex, facsimile ou courriel, un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut éga-
lement  nommer  un  autre  gérant  comme  son  mandataire  par  téléphone,  mais  cette  nomination  devra  ensuite  être
confirmée par écrit.

9.6 Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou

représentés. Les décisions du conseil de gérance ne sont prises valablement qu’à la majorité des voix exprimées. Les
résolutions du conseil de gérance seront consignées dans des procès-verbaux signés par tous les gérants présents ou
représentés à la réunion.

9.7 Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout

autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s’identifier, s’entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en
personne à la réunion.

9.8 Des résolutions circulaires signées par tous les gérants seront valables et engageront la Société comme si elles

avaient été adoptées à une réunion du conseil de gérance dûment convoquée et tenue. Les signatures des gérants peuvent
être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, attestées soit en original soit
en copie émise par télégramme, télex, facsimile ou courriel.

Art. 10. Représentation.
10.1 La société sera engagée par rapport aux tiers par la seule signature de son gérant unique, et, en cas de pluralité

de gérants, par la seule signature d’un membre du conseil de gérance ou par la signature conjointe ou individuelle de
toute personne à qui un tel pouvoir de signature a été délégué par le conseil de gérance.

10.2 La Société sera en outre engagée vis-à-vis des tiers par la signature individuelle ou les signatures conjointes de

toutes personnes à qui un tel pouvoir de signature a été valablement délégué conformément à l’article 8.2 et dans les
limites de ce pouvoir.

175907

L

U X E M B O U R G

Art. 11. Conflit d’intérêts.
11.1 Au cas où un gérant, directeur ou fondé de pouvoir aurait un intérêt personnel dans quelque affaire de la Société,

ce gérant, directeur ou fondé de pouvoir devra informer le conseil de gérance de son intérêt personnel et il ne délibérera
et ne prendra pas part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette affaire et de l’intérêt personnel
de pareil gérant, directeur ou fondé de pouvoir à la prochaine assemblée des actionnaires.

11.2 Nonobstant ce qui précède, aucun contrat et aucune transaction que la Société pourra conclure avec d’autres

sociétés ou firmes ne pourront être affectés ou viciés par le fait qu’un ou plusieurs gérants, directeurs ou fondés de
pouvoir de la Société auraient un intérêt quelconque dans telle autre société ou firme, ou par le fait qu’il en serait gérant,
administrateur, associé, directeur, fondé de pouvoir ou employé. Le gérant, directeur ou fondé de pouvoir de la Société,
qui est gérant, administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou employé d’une société ou firme avec laquelle la Société
passe des contrats, ou avec laquelle elle est autrement en relations d’affaires, ne sera pas par là même privé du droit de
délibérer, de voter et d’agir en ce qui concerne des matières en relation avec pareil contrat ou pareilles affaires.

Art. 12. Responsabilité des gérants.
12.1 Dans le cadre de leur mandat, les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle

concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
pris en conformité avec les Statuts et les dispositions applicables de la Loi.

12.2 Dans la mesure permise par le droit luxembourgeois, et sauf dans les cas prévus à l’article 59, alinéa 2 de la Loi,

un gérant ne sera pas responsable des actes, négligences ou manquements des autres gérants, ou pour toute perte ou
tout dommage causés par une erreur de jugement ou inadvertance de leur part, ou pour toute autre perte, dommage ou
préjudice quelle qu’il soit qui surviendrait lors de l’exécution de son mandat, sauf si cela résulte de, ou est causé par, une
faute lourde ou manquement dolosif lui incombant.

12.3 Dans la mesure permise par le droit luxembourgeois, les gérants et autres fondés de pouvoir de la Société, ainsi

que toutes les personnes à qui des pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à l’article 8.2 seront
indemnisés par prélèvement sur les actifs de la Société contre tous les coûts, frais, pertes, dommages et dépenses encourus
ou supportés par eux en relation avec toutes actions, plaintes, procès ou procédures auxquels ils peuvent être partie en
raison de leur statut actuel ou passé de gérants, fondés de pouvoir ou délégués de la Société, en raison de toute transaction
effectuée par la Société, tout contrat conclu ou action accomplie, ou omise ou dans laquelle ils ont participé, en relation
avec l’exécution de leurs obligations, à l’exception des dommages et dépenses dues à leur faute lourde ou manquement
dolosif, dans chaque cas, sans préjudice de tous les autres droits dont ces personnes peuvent jouir.

IV. Assemblées générales des associés

Art. 13. Pouvoirs et droits de vote.
13.1 L’assemblée générale des associés régulièrement constituée représente l’ensemble des associés de la Société. Elle

a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs à toutes les activités de la Société
dans les limites de la Loi.

13.2 Chaque part sociale donne droit à un vote. Chaque associé a des droits de vote proportionnellement au nombre

de parts détenues par celui-ci.

13.3 Sans préjudice des articles 13.4 et 13.5, les résolutions des associés sont adoptées en assemblées générales.
13.4 Si le nombre d’associés n’excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises par

résolution circulaire. Les associés seront consultés par écrit conformément à l’article 14.2 et exprimeront leur vote en
signant la résolution circulaire. Les associés ont l’obligation d’émettre leur vote écrit et de l’envoyer à la Société dans un
délai de quinze (15) jours suivant l’envoi du texte de la résolution proposée. Les signatures des associés peuvent être
apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, attestées soit en original soit en
copie émise par télégramme, télex, facsimile ou courrier électronique.

13.5 L’associé unique assume tous les pouvoirs conférés par la Loi à l’assemblée générale des associés. Les décisions

de l’associé unique seront consignées en procès-verbaux.

Art. 14. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote.
14.1 Les associés peuvent être convoqués ou consultés par tout gérant de la Société. Le conseil de gérance doit

convoquer ou consulter les associés à la demande des associés représentant plus de la moitié (1/2) du capital social de
la Société.

14.2 Les associés sont convoqués ou consultés par écrit, soit en original ou par télégramme, télex, facsimile ou courrier

électronique.

14.3 Une convocation écrite à toute assemblée des associés sera donnée à tous les associés au moins huit (8) jours

avant la date fixée de l’assemblée, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature de ces circonstances sera précisée dans la
convocation de ladite assemblée.

14.4 Les assemblées des associés de la Société seront tenues aux lieu et heure précisés dans les convocations res-

pectives des assemblées.

175908

L

U X E M B O U R G

14.5 Si tous les associés de la Société sont présents ou représentés à l’assemblée des associés et se considèrent eux-

mêmes  comme  dûment  convoqués  et  informés  de  l’ordre  du  jour  de  l’assemblée,  l’assemblée  pourra  se  tenir  sans
convocation préalable.

14.6 Un associé peut prendre part à toute assemblée générale des associés de la Société en désignant une autre

personne (associé ou non) comme mandataire, un tel mandat sera donné par écrit, soit en original, soit en copie envoyé
par télégramme, télex, facsimile ou courrier électronique.

14.7 Les décisions collectives ne sont valablement prises que dans la mesure où elles sont adoptées par des associés

détenant plus de la moitié (1/2) du capital social. Si ce chiffre n’est pas atteint à la première assemblée ou première
consultation écrite, les associés seront convoqués ou consultés une seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions
seront adoptées à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.

14.8 Cependant, les résolutions pour modifier les Statuts ou pour dissoudre et liquider la Société ne peuvent être

adoptées que par la majorité des associés détenant au moins les trois quarts (3/4) du capital social de la Société. Cependant,
en aucun cas la majorité peut obliger un des associés à augmenter sa participation dans la Société.

14.9 Les associés peuvent changer la nationalité de la Société uniquement par vote unanime.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices

Art. 15. Exercice social et assemblée générale annuelle.
15.1 L’exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un

décembre de la même année.

15.2 Chaque année, à la fin de l’exercice social de la Société, le conseil de gérance dresse le bilan et le compte de

pertes et profits de la Société ainsi qu’un inventaire indiquant la valeur des actifs et passifs de la Société avec une annexe
résumant tous les engagements de la Société et les dettes des gérant(s), auditeur(s) et des associés de la Société.

15.3 Tout associé peut prendre connaissance de ces inventaires et bilan au siège social de la Société.
15.4 Si le nombre d’associés dépasse vingt-cinq (25) associés, l’assemblée générale annuelle des associés sera tenue au

siège social de la Société ou à tout autre endroit dans la commune du siège social tel que précisé dans la convocation.

15.5 Si le nombre d’associés ne dépasse pas vingt-cinq (25) associés, l’assemblée générale des associés se tiendra au

lieu et heure indiqués dans la convocation respective de l’assemblée.

Art. 16. Affectation des bénéfices.
16.1. Cinq pourcent (5%) des bénéfices nets annuels de la Société seront affectés à la réserve requise par la loi. Cette

affectation cessera d’être exigée dès que la réserve légale aura atteint dix pourcent (10%) du capital social de la Société
tel qu’il est fixé ou tel qu’augmenté ou réduit selon l’article 5.

16.2 L’assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l’affectation du solde des bénéfices nets an-

nuels. Elle pourra en particulier allouer ce bénéfice au paiement d’un dividende, l’affecter à la réserve ou le reporter.

16.3 Des dividendes intérimaires peuvent être distribués, à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) un état des comptes ou un inventaire ou un rapport est établi par le conseil de gérance;
(ii) cet état des comptes, inventaire ou rapport montre que des bénéfices et autres réserves (en ce compris la prime

d’émission) suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder
le montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmenté par les bénéfices reportés et les
réserves distribuables mais réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter à la réserve légale;

(iii) la décision de payer des dividendes intérimaires est adoptée par les associés de la Société;
(iv) assurance a été obtenue que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés; et
(v) si, après la clôture de l’exercice social, le montant disponible à la distribution apparaît inférieur au montant distribué

en tant que dividende intérimaire, les associés seront tenus de reverser la différence à la Société.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 17. Dissolution, Liquidation.
17.1 En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, qui n’ont pas

besoin d’être associés, nommés par une résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés qui dé-
terminera leurs pouvoirs et leur rémunération. Sauf disposition contraire prévue par la Loi ou la décision des associés,
les liquidateurs seront investis des pouvoirs les plus larges pour la réalisation des actifs et du paiement des dettes de la
Société.

17.2 Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera distribué

aux associés proportionnellement au nombre d’actions détenues par chaque associé dans la Société.

VII. Dispositions générales

Art. 18. Dispositions générales. Il est fait référence aux dispositions de la Loi et à tout contrat qui peut être conclu

entre les associés de temps à autre (le cas échéant) pour tous les points qui ne font pas l’objet d’une disposition spécifique
dans ces présents Statuts.

175909

L

U X E M B O U R G

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commencera à la date du présent acte et se terminera le 31 décembre 2014.

<i>Souscription et libération

Les 500 (cinq cents) parts sociales représentant l’intégralité du capital social ont toutes été souscrites par Starwood

Capital Operations, LLC, prénommé, et ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que
la somme de GBP 13,000 (treize mille Livres Sterling) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Frais

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution

s’élèvent approximativement à mille quatre cents euros (EUR 1.400).

La somme de GBP 13,000 (treize mille Livres Sterling) correspond à la somme de EUR 16.643,61 (seize mille six cent

quarante-trois Euros soixante et un Eurocent) conformément au taux de change publié sur XE.COM en date du 3 no-
vembre 2014.

<i>Résolutions de l’associé unique

Immédiatement après la constitution de la Société, l’associé de la Société, représentant l’intégralité du capital social

souscrit a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide de fixer à deux (2) le nombre de gérants et de nommer les personnes suivantes en tant que

gérant de la Société pour une période indéterminée:

(i) M. Thierry DRINKA, né à Laon (France) le 11 octobre 1968, avec adresse professionnelle au 3, rue Mozart, L-2166

Luxembourg,

(ii) M. Jerome SILVEY, né en Pennsylvanie (USA) le 27 juin 1957, avec adresse professionnelle au 591 West Putnam

Avenue, Greenwich, CT 06830, Etats-Unis d’Amérique,

<i>Deuxième résolution

Le siège social de la Société est établi au 4, rue Dicks, L-1417 Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête des du mandataire de la partie comparante,

le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française et qu’en cas de divergence entre le texte anglais et
le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé ensemble avec

le notaire le présent acte.

Signé: G. Saddi et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 5 novembre 2014. LAC/2014/51789. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).

<i>Le Receveur (signé): Irène Thill.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 novembre 2014.

Référence de publication: 2014174702/590.
(140199938) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2014.

Petroleum Services Properties S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 4, Zoning Vulcalux.

R.C.S. Luxembourg B 50.560.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fiduciaire ARBO SA
Signature

Référence de publication: 2014173994/11.
(140198559) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.

175910

L

U X E M B O U R G

Open Eyes Invest S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 18-20, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 141.604.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-seventh of October.
Before Us, Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg, Grand Duchy of

Luxembourg.

There appeared

MCH IBERIAN CAPITAL FUND II LP, an English limited partnership registered under the Limited Partnership Act

1907 with number LP 9531, whose registered office is set at 47 Esplanade, St. Helier, Jersey JE1, OBD acting by its managing
general partner IBERIAN CAPITAL FUND II, LIMITED, holder of 100% of the shares of the Company (the “Sole Share-
holder”),

represented by Mr Frank Stolz-Page, with professional address in Mondorf-les-Bains,
by virtue of proxy under private seal given on 24 October 2014.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and

the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, acting in the here above stated capacity, requested the undersigned notary to state that it holds

100% of shares of "Open Eyes Invest S.à r.l.", a private limited liability company (société à responsabilité limitée), existing
under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office 18-20, rue Edward Steichen, L-2540
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 141.604, incorporated by
a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on September 11, 2008,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 2405 page 115429 on October 2, 2008
(the “Company”).

The articles of association of the Company have not been amended since the incorporation of the Company.
The Sole Shareholder declared and requested the notary to record the following:

<i>First resolution

The Sole shareholder RESOLVES to approve the interim financial statements of the Company for the period from

January 2014 to the date of the present resolutions.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder RESOLVES to grant discharge to the members of the board of managers (“conseil de gérance”)

of the Company with respect to the performance of their duties for the period from 1 

st

 January 2014 to the date hereof.

<i>Third resolution

In compliance with articles 141-151 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended from time

to time (the “Law”), the Sole Shareholder RESOLVES to dissolve the Company and to put it into liquidation.

<i>Fourth resolution

The Sole Shareholder RESOLVES to appoint as liquidator (“liquidateur”) of the Company:
Damsor Limited, a company duly organised and existing under the laws of the United Kingdom with its registered

office at 18 South Street, Mayfair, London, United Kingdom, W1K 1DG, (the “Liquidator”), recorded with the Registrar
of Companies for England and Wales, United Kingdom, under the number 4829974.

The aforesaid Liquidator has to realise all of the assets and liabilities of the Company. The Liquidator is exempted from

the obligation of drawing up an inventory, and may in this respect rely fully on the books of the Company, especially the
interim financial statements drawn up as at the date of the present resolutions.

The Liquidator may under its own responsibility and regarding special or specific transactions, delegate such part of

its powers as it may deem fit, to one or several representatives.

The Liquidator binds validly and without limitation the Company in the process of being liquidated.
The Liquidator has the authority to perform and execute all transactions provided for in Articles 144 and 145 of the

Law, without specific authorisation therefore from the general meeting shareholder of the Sole Shareholder.

The Liquidator may pay advances on the liquidation surplus after having paid the debts or made the necessary provisions

for the payment of the debts or it may transfer all assets and liabilities of the Company to its sole shareholder upon
commitment of the latter to pay any debts incurred presently or in the future.

175911

L

U X E M B O U R G

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand seven hundred
euro (EUR 1,700.-).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded

in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.

WHEREOF the present deed was drawn up in Mondorf-les-Bains, at the office of the undersigned notary, on the day

named at the beginning of this document.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the said proxyholder signed together with

the undersigned notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le vingt-sept du mois d’octobre.
Par devant Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu

MCH IBERIAN CAPITAL FUND II LP, un limited partnership anglais, enregistré auprès du Limited Partnership Act

1907 sous le numéro LP 9531 dont le siège est établi au 47 Esplanade, St. Helier, Jersey JE1, OBD agissant par le biais de
son managing partner IBERIAN CAPITAL FUND II, LIMITED, détenteur de 100% des parts sociales de la Société (l’«As-
socié Unique»),

représenté par Monsieur Frank Stolz-Page, avec adresse professionnelle à Mondorf-les-Bains,
en vertu d’une procuration sous seing privée donnée en date du 24 octobre 2014.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante

et par le notaire instrumentant restera annexée aux présentes pour les besoins de l’enregistrement.

La partie comparante, agissant, es-qualité, a requis le notaire instrumentant d’acter qu’elle détient 100% des parts

sociales de «Open Eyes Invest S.à r.l.» une société à responsabilité limitée existant sous les lois du Grand-Duché de
Luxembourg, ayant son siège social au 18-20, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 141.604, constituée suivant un acte reçu par Maître
Martine Schaeffer, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, daté du 11 septembre 2008, publié au
Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 2405 page 115429 du 2 octobre 2008 (la «Société»).

Les statuts de la Société n’ont pas été modifiés depuis sa constitution.
L’Associé Unique déclare et requiert le notaire instrumentant d’acter que:

<i>Première résolution

L’Associé Unique DECIDE d’approuver les états financiers intérimaires de la Société du 1 

er

 janvier 2014 jusqu’au jour

des présentes résolutions.

<i>Seconde résolution

L’Associé Unique DECIDE d’accorder décharge aux membres du conseil de gérance de la Société pour l’accomplis-

sement de leurs mandats pour la période allant du 1 

er

 janvier 2014 jusqu’à ce jour.

<i>Troisième résolution

Conformément aux articles 141-151 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée (la

«Loi»), l’Associé Unique DECIDE de dissoudre la Société et de procéder à sa mise en liquidation volontaire.

<i>Quatrième résolution

L’Associé Unique DECIDE de nommer en tant que liquidateur de la Société:
Damsor Limited, une société existant sous les lois du Royaume-Uni, ayant son siège social au 18 South Street, Mayfair,

London, Royaume Uni, W1K 1DG, (le «Liquidateur»), inscrite au Registrar of Companies for England and Wales, Royaume
Uni, sous le numéro 4829974.

Le Liquidateur prénommé a la mission de réaliser tout l’actif et d’apurer le passif de la Société. Le Liquidateur est

dispensé de l’obligation de dresser un inventaire et peut à ce titre se référer pleinement aux écritures de la Société sur
la comptabilité de la Société, en particulier les états financiers intérimaires au jour des présentes résolutions.

Le Liquidateur pourra sous sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer tout ou

partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires.

Le Liquidateur peut engager valablement et sans limitation la Société en cours de liquidation.
Le Liquidateur dispose du pouvoir pour toutes les opérations prévus aux Articles 144 et 145 de la Loi, sans avoir

besoin d’être préalablement autorisé par l’assemblée générale de l’Associé Unique.

175912

L

U X E M B O U R G

Le Liquidateur peut payer des avances sur le boni de liquidation après avoir payé les dettes ou avoir fait les provisions

nécessaires pour le paiement des dettes ou il peut transférer tout l’actif et le passif de la Société à son associé unique sur
accord de ce dernier de payer toutes les dettes actuelles encourues ou futures.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou

mises à sa charge en raison des présentes est évalué à mille sept cents euros (EUR 1.700,-).

Le notaire instrumentant qui comprend et parle l’anglais, déclare qu'à la demande de la partie comparante, le présent

acte est écrit en anglais, suivi d'une version en langue française. A la demande de la même partie comparante, il est déclaré
qu'en cas de désaccord entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra.

DONT ACTE, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l’étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.
Lecture faite au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé l’original du présent acte avec le notaire instru-

mentant.

Signé: F. Stolz-Page, M. Loesch.
Enregistré à Remich, le 28 octobre 2014. REM/2014/2357. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): P. MOLLING.

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 10 novembre 2014.

Référence de publication: 2014173958/123.
(140199375) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.

Preafin III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2529 Howald, 37, rue des Scillas.

R.C.S. Luxembourg B 82.632.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-third day of the month of October;
Before the undersigned notary Carlo WERSANDT, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg);

THERE APPEARED:

The company Fresenius Medical Care Beteiligungsgesellschaft mbH, a private limited liability company duly organized

under German law, having its business address at D-61352 Bad Homburg v.d.H., Else-Kröner-Str.1, representing the full
amount of the corporate capital of EUR 3,203,900 (three million two hundred three thousand nine hundred euro) of
PREAFIN III S.à r.l., a private limited liability company (“société à responsabilité limitée”) incorporated under the laws of
the Grand-Duchy of Luxembourg, with registered office at 37, rue des Scillas, 2529 Howald, Grand-Duchy of Luxembourg,
registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 82632, (the “Company”), represented
by 32,039 (thirty-two thousand thirty-nine) sharequotas with a par value of EUR 100 (one hundred Euro) each,

duly represented by Mrs. Mevlüde-Aysun TOKBAG, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under

private seal.

The said proxy, after having been signed “ne varietur” by the proxy of the appearing person and the undersigned

notary, will remain attached to the present deed to be filed together with the registration authorities.

The afore-mentioned Fresenius Medical Care Beteiligungsgesellschaft mbH is the sole member (the “Sole Member”)

of the Company, incorporated pursuant to a deed of Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand-Duchy
of Luxembourg, on June 11, 2001, published in the Official Gazette of the Grand-Duchy of Luxembourg (“Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations”), N° 1218, dated December 22, 2001, which articles have been amended several
times and for the last time by a deed of the undersigned notary dated October 29, 2013, published in the Official Gazette
of the Grand-Duchy of Luxembourg (“Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations”), N° 3179, dated December
13, 2013.

The appearing party, represented as here above stated, in its capacity as Sole Member of the Company has requested

the undersigned notary to state the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Member resolves to increase the corporate capital of the Company by an amount of EUR 325,300.- (three

hundred twenty-five thousand three hundred Euro) in order to bring it from its present amount of EUR 3,203,900.- (three
million two hundred three thousand nine hundred Euro) represented by 32,039 (thirty-two thousand thirty-nine) sha-
requotas with a par value of EUR 100.- (one hundred Euro) each, to the amount of EUR 3,529,200.- (three million five
hundred twenty-nine thousand two hundred Euro) represented by 35,292 (thirty-five thousand two hundred ninety-two)
sharequotas with a par value of EUR 100.- (one hundred euro) each, by issuing 3,253 (three thousand two hundred fifty-
three) new sharequotas with a par value of EUR 100.- (one hundred Euro) each, together with a total share premium of

175913

L

U X E M B O U R G

EUR 2,927,700.- (two million nine hundred twenty-seven thousand seven hundred Euro), having the same rights and
obligations as the existing sharequotas.

<i>Second resolution

The Sole Member resolves to issue 3,253 (three thousand two hundred fifty-three) new sharequotas with a par value

of EUR 100.- (one hundred euro) each, together with a total share premium of EUR 2,927,700.- (two million nine hundred
twenty-seven thousand seven hundred Euro), having the same rights and obligations as the existing sharequotas.

<i>Subscription and payment

There now appears Mrs. Mevlüde-Aysun TOKBAG, previously named, acting in her capacity as duly appointed attorney

in fact of the Sole Member.

The appearing person declares subscribing in the name and on behalf of the Sole Member 3,253 (three thousand two

hundred fifty-three) new sharequotas with a par value of EUR 100.- (one hundred Euro) each, together with a total share
premium of EUR 2,927,700.- (two million nine hundred twenty-seven thousand seven hundred Euro) by contribution and
transformation into capital of unquestionable, liquid and enforceable claims the Sole Member has against the Company
for a total amount of EUR 3,253,000.- (three million two hundred fifty-three thousand Euro), consequently, those claims
are cancelled to the extent of the amount of the contribution.

Based on a valuation report issued by the Sole Member on October 6, 2014, the unquestionable, liquid and enforceable

claims of the Sole Member to be contributed to the Company have been valued at EUR 3,253,000.- (three million two
hundred fifty-three thousand Euro) (the “First Valuation Report”).

The conclusion of the First Valuation Report is as follows:
"The value of the unquestionable, liquid and enforceable claims to be contributed by the Contributor to the Company

is at least equal to the consideration, being 3,253 (three thousand two hundred fifty-three) new sharequotas with a par
value of EUR 100.- (one hundred Euro) each, together with a total share premium of EUR 2,927,700.- (two million nine
hundred twenty-seven thousand seven hundred Euro) to be issued by the Company”.

Such First Valuation Report, after having been signed "ne varietur" by the appearing person and the notary, will remain

attached to the present deed to be filed together with it with the registration authorities.

Thereupon, the Sole Member formally resolves to accept the said subscription, contribution and transformation of

claims and to issue and allot 3,253 (three thousand two hundred fifty-three) new fully paid-up sharequotas of the Company
to itself.

<i>Third resolution

The Sole Member resolves to increase the corporate capital of the Company by an amount of EUR 538,200.- (five

hundred thirty-eight thousand two hundred Euro) in order to bring it from its present amount of EUR 3,529,200.- (three
million five hundred twenty-nine thousand two hundred Euro) represented by 35,292 (thirty-five thousand two hundred
ninety-two) sharequotas with a par value of EUR 100.- (one hundred Euro) each, to the amount of EUR 4,067,400.- (four
million sixty-seven thousand four hundred Euro) represented by 40,674 (forty thousand six hundred seventy-four) sha-
requotas with a par value of EUR 100.- (one hundred Euro) each, by issuing 5,382 (five thousand three hundred eighty-
two) new sharequotas with a par value of EUR 100.- (one hundred Euro) each, together with a total share premium of
EUR 4,843,861.13 (four million eight hundred forty-three thousand eight hundred sixty-one Euro and thirteen Cents),
having the same rights and obligations as the existing sharequotas.

<i>Fourth resolution

The Sole Member resolves to issue 5,382 (five thousand three hundred eighty-two) new sharequotas with a par value

of EUR 100.- (one hundred Euro) each, together with a total share premium of EUR 4,843,861.13 (four million eight
hundred forty-three thousand eight hundred sixty-one Euro and thirteen Cents), having the same rights and obligations
as the existing sharequotas.

<i>Subscription and payment

There now appears Mrs. Mevlüde-Aysun TOKBAG, previously named, acting in her capacity as duly appointed attorney

in fact of the Sole Member.

The appearing person declares subscribing in the name and on behalf of the Sole Member 5,382 (five thousand three

hundred eighty-two) new sharequotas with a par value of EUR 100.- (one hundred Euro) each, together with a total share
premium of EUR 4,843,861.13 (four million eight hundred forty-three thousand eight hundred sixty-one Euro and thirteen
Cents) by contribution and transformation into capital of unquestionable, liquid and enforceable claims the Sole Member
has against the Company for a total amount of EUR 5,382,061.13 (five million three hundred eighty-two thousand sixty-
one Euro and thirteen Cents), consequently, those claims are cancelled to the extent of the amount of the contribution.

Based on a valuation report issued by the Sole Member on October 6, 2014, the unquestionable, liquid and enforceable

claims of the Sole Member to be contributed to the Company have been valued at EUR 5,382,061.13 (five million three
hundred eighty-two thousand sixty-one Euro and thirteen Cents) (the “Second Valuation Report”).

175914

L

U X E M B O U R G

The conclusion of the Second Valuation Report is as follows:
"The value of the unquestionable, liquid and enforceable claims to be contributed by the Contributor to the Company

is at least equal to the consideration, being 5,382 (five thousand three hundred eighty-two) new sharequotas with a par
value of EUR 100.- (one hundred Euro) each, together with a total share premium of EUR 4,843,861.13 (four million eight
hundred forty-three thousand eight hundred sixty-one Euro and thirteen Cents) to be issued by the Company”.

Such report, after having been signed "ne varietur" by the appearing person and the notary, will remain attached to

the present deed to be filed together with it with the registration authorities.

Thereupon, the Sole Member formally resolves to accept the said subscription, contribution and transformation of

claims and to issue and allot 5,382 (five thousand three hundred eighty-two) new fully paid-up sharequotas of the Company
to itself.

<i>Fifth resolution

The Sole Member resolves to amend article 6 of the articles of association of the Company, so as to reflect the above

resolutions and to read as follows:

"The corporate capital is set at EUR 4,067,400.- (four million sixty-seven thousand four hundred Euro) represented

by 40,674 (forty thousand six hundred seventy-four) sharequotas with a par value of EUR 100.- (one hundred Euro) each,
which have been subscribed and entirely paid-in by Fresenius Medical Care Beteiligungsgesellschaft mbH, a private limited
company registered in Germany, Bad Homburg v.d.H., having its business address in Germany, D-61352 Bad Homburg
v.d.H., Else-Kroner-Strasse 1."

<i>Sixth resolution

The Sole Member resolves to grant mandate to the law firm Wildgen, Partners in Law, with offices at 69, boulevard

de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, to perform all legal action in relation with the aforesaid resolutions, and in particular,
to update the member's register.

<i>Costs, Evaluation

The expenses, costs, fees and outgoings of any kind whatsoever borne by the Company, as a result of the presently

stated, are evaluated at approximately four thousand seven hundred Euros (EUR 4,700.-).

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith, that on request of the appearing person,

the present deed is worded in English, followed by a German version. In case of discrepancies between the English and
the German text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing party, the latter signed together with the notary the present deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des Vorangehenden:

Im Jahre zweitausendvierzehn, am dreiundzwanzigsten Tage des Monats Oktober;
Vor dem unterzeichneten Notar Carlo WERSANDT, ansässig in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg);

IST ERSCHIENEN:

Die Gesellschaft Fresenius Medical Care Beteiligungsgesellschaft mbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung

deutschen Rechts, mit Sitz in D-61352 Bad Homburg v.d.H., Else-Kröner-Str.1, welche das gesamte Gesellschaftskapital
von EUR 3.203.900 (drei Millionen zweihundertdreitausendneunhundert Euro der PREAFIN III S.à r.l., eine Gesellschaft
mit beschränkter Haftung („société à responsabilité limitée“), gegründet gemäß den Gesetzen des Großherzogtums Lu-
xemburg, mit Sitz in 37, rue des Scillas, 2529 Howald, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels-/
und Gesellschaftsregister unter Nummer B 82632 (die „Gesellschaft“), eingeteilt in 32.039 (zweiunddreißigtausendneu-
nunddreißig) Geschäftsanteile mit einem Nennwert von je EUR 100 (einhundert Euro) repräsentiert,

ordnungsgemäß vertreten durch Frau Mevlüde-Aysun TOKBAG, Rechtsanwältin, wohnhaft in Luxemburg, kraft pri-

vatschriftlicher Vollmacht.

Besagte Vollmacht verbleibt nach „ne varietur“ Zeichnung durch die Bevollmächtigte der erschienenen Partei und den

unterzeichnenden Notar anliegend an der vorliegenden Urkunde, um mit dieser gleichzeitig bei Registrierungsbehörden
eingereicht zu werden.

Die vorgenannte Fresenius Medical Care Beteiligungsgesellschaft mbH ist Alleingesellschafter (der „Alleingesellschaf-

ter“) der Gesellschaft, gegründet durch Urkunde von Maître Jean SECKLER, Notar mit Amtssitz in Junglinster vom 11.
Juni 2001, veröffentlicht im Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg („Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions“), Nr. 1218 vom 22. Dezember 2001, deren Satzung mehrmals abgeändert worden ist und zuletzt durch notarielle
Urkunde des unterzeichnenden Notars vom 29. Oktober 2013, veröffentlicht im Amtsblatt des Großherzogtums Lu-
xemburg („Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations“), Nr. 3179 vom 13. Dezember 2013.

Die erschienene Partei, wie oben genannt vertreten, ersucht den unterzeichneten Notar in ihrer Eigenschaft als Al-

leingesellschafter der Gesellschaft, die folgenden Beschlüsse aufzunehmen:

175915

L

U X E M B O U R G

<i>Erster Beschluss

Der Alleingesellschafter beschließt, das Gesellschaftskapital um den Betrag von EUR 325.300,- (dreihundertfünfund-

zwanzigtausenddreihundert Euro) von seiner gegenwärtigen Höhe von EUR 3.203.900,- (drei Millionen zweihundertd-
reitausendneunhundert Euro), eingeteilt in 32.039 (zweiunddreißigtausendneununddreißig) Geschäftsanteile mit einem
Nennwert von je EUR 100,- (hundert Euro), auf den Betrag von EUR 3.529.200 (drei Millionen fünfhundertneunund-
zwanzigtausendzweihundert Euro), eingeteilt in 35.292 (fünfunddreißigtausendzweihundertzweiundneunzig) Geschäfts-
anteile mit einem Nennwert von je EUR 100,- (einhundert Euro), durch Ausgabe von 3.253 (dreitausendzweihundertd-
reiundfünfzig) neuen Gesellschaftsanteilen mit einem Nennwert von je EUR 100,- (einhundert Euro), zusammen mit einem
Agio in Höhe von EUR 2.927.700,- (zwei Millionen neunhundertsiebenundzwanzigtausendsiebenhundert Euro), die die-
selben Rechte und Pflichten wie die vorhandenen Gesellschaftsanteile haben, zu erhöhen.

<i>Zweiter Beschluss

Der  Alleingesellschafter  beschließt  3.253  (dreitausendzweihundertdreiundfünfzig)  neue  Geschäftsanteile  mit  einem

Nennwert von je EUR 100,- (einhundert Euro), zusammen mit einem Agio in Höhe von insgesamt EUR 2.927.700,- (zwei
Millionen neunhundertsiebenundzwanzigtausendsiebenhundert Euro), welche mit den gleichen Rechte und Pflichten ver-
bunden sind, wie die bereits vorhandenen Geschäftsanteile, auszugeben.

<i>Zeichnung und Zahlung

Es erscheint nun Frau Mevlüde-Aysun TOKBAG, vorbenannt, handelnd in ihrer Eigenschaft als Bevollmächtigte des

Alleingesellschafters.

Die Erschienene erklärt, im Namen des Alleingesellschafters 3.253 (dreitausendzweihundertdreiundfünfzig) neu aus-

gegebene Geschäftsanteile mit einem Nennwert von je EUR 100,- (ein hundert Euro) der Gesellschaft zusammen mit
einem gesamten Agio von EUR 2.927.700,- (zwei Millionen neunhundertsiebenundzwanzigtausendsiebenhundert Euro) zu
zeichnen, und diese Geschäftsanteile durch Sacheinlage und Umwandlung in Kapital von unbestrittenen, liquiden und
durchsetzbaren Forderungen, die der Alleingesellschafter gegen die Gesellschaft in Höhe von EUR 3.253.000,- (drei Mil-
lionen zweihundertdreiundfünfzigtausend Euro) hat, voll einzuzahlen, woraufhin diese Forderungen bis zur Höhe der
Sacheinlage erlöschen.

Basierend auf einem Bewertungsbericht des Alleingesellschafters vom 6. Oktober 2014, wurden die unbestrittenen,

liquiden und durchsetzbaren Forderungen des Alleingesellschafters, welche gegenüber der Gesellschaft eingebracht wer-
den sollen, mit EUR 3.253.000,- (drei Millionen zweihundertdreiundfünfzigtausend Euro) bewertet (der “Erste Bewer-
tungsbericht“).

Der Erste Bewertungsbericht kommt zu folgendem Schluss:
“Der Wert der unbestrittenen, liquiden und durchsetzbaren Forderungen, die durch den Einlegenden gegenüber der

Gesellschaft eingebracht werden, entspricht mindestens dem Wert der im Gegenzug ausgegebenen 3.253 (dreitausend-
zweihundertdreiundfünfzig) neuen Geschäftsanteile mit einem Nennwert von je EUR 100,- (ein hundert Euro) und dem
hiermit verbundenen Agio in Höhe von EUR 2.927.700,- (zwei Millionen neunhundertsiebenundzwanzigtausendsieben-
hundert Euro Euro).“

Nachdem der Erste Bewertungsbericht durch die erschienene Person und den unterzeichneten Notar “ne varietur“

unterzeichnet worden ist, bleibt er an dieser Urkunde anliegend, um gleichzeitig bei den Registrierungsbehörden einge-
reicht zu werden.

Daraufhin beschließt der Alleingesellschafter förmlich, die vorgenannte Zeichnung, Sacheinlage und Umwandlung an-

zunehmen und 3.253 (dreitausendzweihundertdreiundfünfzig) neue, voll eingezahlte Geschäftsanteile der Gesellschaft ihr
selbst zuzuteilen.

<i>Dritter Beschluss

Der Alleingesellschafter beschließt, das Gesellschaftskapital um den Betrag von EUR 538.200,- (fünfhundertachtundd-

reißigtausendzweihundert  Euro)  von  seiner  gegenwärtigen  Höhe  von  EUR  3.529.200  (drei  Millionen  fünfhundertneu-
nundzwanzigtausendzweihundert  Euro),  eingeteilt  in  35.292  (fünfunddreißigtausendzweihundertzweiundneunzig)  Ge-
schäftsanteile mit einem Nennwert von je EUR 100,- (einhundert Euro), auf den Betrag von EUR 4.067.400,- (vier Millionen
siebenundsechzigtausendvierhundert Euro), eingeteilt in 40.674 (vierzigtausendsechshundertvierundsiebzig) Geschäfts-
anteile mit einem Nennwert von je EUR 100,- (einhundert Euro), durch Ausgabe von 5.382 (fünftausenddreihundert-
zweiundachtzig) neuen Gesellschaftsanteilen mit einem Nennwert von je EUR 100,- (einhundert Euro), zusammen mit
einem Agio in Höhe von EUR 4.843.861,13 (vier Millionen achthundertdreiundvierzigtausendachthunderteinundsechzig
Euro und dreizehn Cents), die dieselben Rechte und Pflichten wie die vorhandenen Gesellschaftsanteile haben, zu erhöhen.

<i>Vierter Beschluss

Der Alleingesellschafter beschließt 5.382 (fünftausenddreihundertzweiundachtzig) neue Geschäftsanteile mit einem

Nennwert von je EUR 100,- (einhundert Euro), zusammen mit einem Agio in Höhe von insgesamt EUR 4.843.861,13 (vier
Millionen achthundertdreiundvierzigtausendachthunderteinundsechzig Euro und dreizehn Cents), welche mit den gleichen
Rechte und Pflichten verbunden sind, wie die bereits vorhandenen Geschäftsanteile, auszugeben.

175916

L

U X E M B O U R G

<i>Zeichnung und Zahlung

Es erscheint nun Frau Mevlüde-Aysun TOKBAG, vorbenannt, handelnd in ihrer Eigenschaft als Bevollmächtigte des

Alleingesellschafters.

Die Erschienene erklärt, im Namen des Alleingesellschafters 5.382 (fünftausenddreihundertzweiundachtzig) neu aus-

gegebene Geschäftsanteile mit einem Nennwert von je EUR 100,- (einhundert Euro) der Gesellschaft zusammen mit
einem gesamten Agio von EUR 4.843.861,13 (vier Millionen achthundertdreiundvierzigtausendachthunderteinundsechzig
Euro und dreizehn Cents) zu zeichnen, und diese Geschäftsanteile durch Sacheinlage und Umwandlung in Kapital von
unbestrittenen, liquiden und durchsetzbaren Forderungen, die der Alleingesellschafter gegen die Gesellschaft in Höhe von
EUR 5.382.061,13 (fünf Millionen dreihundertzweiundachtzigtausendeinundsechzig Euro und dreizehn Cents) hat, voll
einzuzahlen, woraufhin diese Forderungen bis zur Höhe der Sacheinlage erlöschen.

Basierend auf einem Bewertungsbericht des Alleingesellschafters vom 6. Oktober 2014, wurden die unbestrittenen,

liquiden und durchsetzbaren Forderungen des Alleingesellschafters, welche gegenüber der Gesellschaft eingebracht wer-
den  sollen,  mit  EUR  5.382.061,13  (fünf  Millionen  dreihundertzweiundachtzigtausendeinundsechzig  Euro  und  dreizehn
Cents) bewertet (der “Zweite Bewertungsbericht“).

Der Zweite Bewertungsbericht kommt zu folgendem Schluss:
“Der Wert der unbestrittenen, liquiden und durchsetzbaren Forderungen, die durch den Einlegenden gegenüber der

Gesellschaft eingebracht werden, entspricht mindestens dem Wert der im Gegenzug ausgegebenen 5.382 (fünftausendd-
reihundertzweiundachtzig) neuen Geschäftsanteile mit einem Nennwert von je EUR 100,- (ein hundert Euro) und dem
hiermit verbundenen Agio in Höhe von EUR 4.843.861,13 (vier Millionen achthundertdreiundvierzigtausendachthunder-
teinundsechzig Euro und dreizehn Cents) Euro).“

Nachdem der Zweite Bewertungsbericht durch die erschienene Person und den unterzeichneten Notar “ne varietur“

unterzeichnet worden ist, bleibt er an dieser Urkunde anliegend, um gleichzeitig bei den Registrierungsbehörden einge-
reicht zu werden.

Daraufhin beschließt der Alleingesellschafter förmlich, die vorgenannte Zeichnung, Sacheinlage und Umwandlung an-

zunehmen und 5.382 (fünftausenddreihundertzweiundachtzig) neue, voll eingezahlte Geschäftsanteile der Gesellschaft ihr
selbst zuzuteilen.

<i>Fünfter Beschluss

Der Alleingesellschafter beschließt, Artikel 6 der Satzung der Gesellschaft zu ändern, um die oben stehenden Beschlüsse

widerzuspiegeln, welcher nun folgenden neuen Wortlaut haben wird:

"Das Gesellschaftskapital ist EUR 4.067.400 (vier Millionen siebenundsechzigtausendvierhundert Euro), eingeteilt in

40.674 (vierzigtausendsechshundertvierundsiebzig) Geschäftsanteile mit einem Nennwert von je EUR 100,- (ein hundert
Euro), welche alle von Fresenius Medical Care Beteiligungsgesellschaft mbH, einer Gesellschaft eingetragen in Deutsch-
land, Bad Homburg v.d.H., mit Geschäftsadresse in Deutschland, D-61352 Bad Homburg v.d.H., Else-Kröner-Strasse 1,
gezeichnet worden sind."

<i>Sechster Beschluss

Der Alleingesellschafter beschließt, der Kanzlei Wildgen Partners in Law, mit Sitz in 69, boulevard de la Pétrusse,

L-2320 Luxemburg, Mandat zur Wahrnehmung aller rechtlichen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Tagesordnung
der Versammlung und insbesondere zur Aktualisierung des Gesellschafterregisters zu erteilen.

<i>Kosten, Bewertungen

Die Kosten, Gebühren und anderen Auslagen die der Gesellschaft aus der vorliegenden Urkunde entstehen, werden

auf ungefähr viertausendsiebenhundert Euro (EUR 4.700,-) geschätzt.

Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache versteht und spricht, stellt hiermit fest, dass auf Antrag der

Erschienenen, die vorliegende Urkunde in Englisch abgefasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung. Im Fall von Abwei-
chungen zwischen dem englischen und deutschen Wortlaut die englische Fassung Vorrang haben soll.

WORÜBER die vorliegende Urkunde am Tag wie eingangs dieser Urkunde genannt in Luxemburg erstellt wurde.
Nach Verlesung der Urkunde vor der Erschienenen, wurde die vorliegende Urkunde von dieser zusammen mit dem

Notar unterzeichnet.

Signé: M-A. TOKBAG, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 28 october 2014. LAC/2014/50102. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 10 novembre 2014.

Référence de publication: 2014174002/255.
(140199265) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.

175917

L

U X E M B O U R G

Montblanc Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 3.447.232,00.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 145.539.

In the year two thousand and fourteen, on the thirtieth day of September.
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Sunshine View Limited LLC, a limited liability corporation (LLC) incorporated and organized under the laws of Hong

Kong, having its registered office at 14 

th

 Floor, Golden Centre, 188 Des Voeux Road Central, Hong Kong, registered

with the Hong Kong Register of Companies, under number 1278086,

being the sole shareholder (the Sole Shareholder) of Montblanc Management S.à r.l., (formerly known as Montblanc

Luxembourg S.à r.l.) a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under
the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 145.539
and having a share capital of two million four hundred ninety-nine thousand six hundred twenty-five euro (EUR 2,499,625)
(the Company), incorporated by notarial deed on 24 March 2009, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et
Associations on 17 April 2009 under number 830, page number 39806. The articles of association of the Company (the
Articles) have been amended for the last time by notarial deed on 27 June 2014, published in the Memorial C, Recueil
des Sociétés et Associations dated July 1, 2014 under number 2399, page number 110483 and seq.

Here represented by Régis Galiotto, notary clerk, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power of

attorney given under private seal.

The said power of attorney, after having been signed ne varietur by the representative of the appearing party and the

undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated above, has requested the undersigned notary to enact the following:
I. The Sole shareholder holds one hundred per cent (100%) of the shares in the share capital of the Company;
II. The Sole Shareholder resolves to take the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to introduce the United States Dollar (USD) as official and accounting currency of the

Company with retroactive effect as of January 1 

st

 , 2014.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolves that the Company adopts the United States Dollar (USD) as its share capital currency

at the closing exchange rate published by the European Central Bank on December 31, 2013 and according to which EUR
1 equals USD 1.3791, so that the share capital of the Company now amounts to three million four hundred forty-seven
thousand two hundred thirty-two United States Dollars (USD 3,447,232.-) which remain entirely allocated to the share
capital account of the Company.

Proof of the above exchange rate has been given to the notary through a financial publication that will remain attached

to the present deed, after having been signed ne varietur by the proxyholder representing the Sole Shareholder and the
notary.

<i>Third resolution

The Sole Shareholder resolves to set the par value of the shares at one United States Dollar (USD 1.-) each.
The Sole Shareholder resolves to set the number of shares at three million four hundred forty-seven thousand two

hundred thirty-two (3,447,232) with a par value of one United States Dollar (USD 1.-) each, in exchange and replacement
of the existing hundred twenty-five (19,997) shares having a nominal value of one hundred twenty-five Euros (EUR 125.-)
each.

<i>Fourth resolution

As a consequence of the preceding resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend article 5.1 of the Articles, so

that it shall henceforth in its relevant part read as follows:

“ 5.1. The share capital is set at three million four hundred forty-seven thousand two hundred thirty-two United States

Dollars (USD 3,447,232.-), represented by three million four hundred forty-seven thousand two hundred thirty-two
(3,447,232.-) shares in registered form, having a par value of one United States Dollar (USD 1.-) each, all subscribed and
fully paid-up.”

175918

L

U X E M B O U R G

<i>Fifth resolution

The Sole Shareholder resolves to amend the books and registers of the Company in order to reflect the above changes

with power and authority to any manager of the Company to proceed individually, with full power of substitution, on
behalf of the Company, with the registration of the above changes in the relevant books and registers of the Company.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately one thousand five hundred Euros (EUR 1,500.-).

<i>Statement

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,

the present deed is worded in English followed by a German version; at the request of the Sole Shareholder, it is stated
that, in case of discrepancies between the English and the German texts, the English version shall prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with us,

the notary, the present original deed.

Deutsche Uebersetzung des Vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendundvierzehn, am dreißigsten September,
Vor mir, dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,

IST ERSCHIENEN:

Sunshine View Limited LLC, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (LLC), die gemäß den Gesetzen Hongkongs

organisiert und registriert ist, mit Gesellschaftssitz in 14. Geschoss, Golden Centre, 188 Des Voeux Road Central, Hong-
kong, eingetragen beim Gesellschaftsregister Hongkongs unter der Nummer 1278086,

alleiniger Gesellschafter (der Alleinige Gesellschafter) der Montblanc Management S.à r.l., (vormals Montblanc Lu-

xembourg S.à r.l.), eine Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) luxemburgischen
Rechts, mit Gesellschaftssitz 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Lu-
xemburger Handelsund Gesellschaftsregister unter der Nummer B 145.539mit einem Stammkapital in Höhe von zwei
Millionen vier hundert neunundneunzig tausend sechs hundert fünfundzwanzig Euro (EUR 2.499.625) (die Gesellschaft),
gegründet gemäß einer Urkunde vom 24. März 2009, veröffentlicht im Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations
am 17 April 2009 unter der Nummer 830, auf Seite 39806. Die Statuten der Gesellschaft (die Statuten) wurden zum
letzten Mal gemäß einer Urkunde vom 27. Juni 2014, welche noch nicht im Memorial C, Recueil des Sociétés et Associ-
ations, datiert vom 1. Juli und mit Folgenummer 2399, Seitenzahl 110483 f. veröffentlich wurde, geändert.

Hier vertreten durch Régis Galiotto, Notarsekretär, beruflich ansässig in Luxemburg, aufgrund einer privatrechtlichen

Vollmacht.

Nach ne varietur Unterzeichnung von dem Stellvertreter der erschienenen Partei und dem unterzeichnenden Notar,

wird die besagte Vollmacht der vorliegenden Urkunde zur Registrierung beigefügt.

Die erschienene Partei, vertreten wie oben dargestellt, hat den unterzeichneten Notar ersucht, Folgendes zu beur-

kunden:

III. Der Alleinige Gesellschafter hält hundert Prozent (100%) der Gesellschaftsanteile im Stammkapital der Gesellschaft;
IV. Der Alleinige Gesellschafter beschließt folgende Beschlüsse zu fassen:

<i>Erster Beschluss

Der Alleinige Gesellschafter beschließt den Dollar der Vereinigten Staaten (USD) als offizielle und Rechnungswährung

der Gesellschaft einzuführen, rückwirkend zum 1. Januar 2014.

<i>Zweiter Beschluss

Der Alleinige Gesellschafter beschließt, dass die Gesellschaft den Dollar der Vereinigten Staaten (USD) als ihre Akti-

enkapitalwährung zum Stichtageskurs festlegt, der durch die Europäische Zentralbank am 31. Dezember 2013 veröffent-
licht wurde und laut dem, 1 EUR, 1.3791 USD entspricht, sodass das Stammkapital der Gesellschaft nun drei Millionen
vier hundert sieben und vierzig tausend zweihundertzweiunddreißig Dollar der Vereinigten Staaten (USD 3.447.232)
beträgt, das gänzlich auf dem Konto des Unternehmens verbleibt.

Ein Nachweis des oben genannten Wechselkurses wurde dem amtierenden Notar durch eine Finanzpublikation er-

bracht, die der vorliegenden Urkunde beigefügt wird, nach dem diese von dem Stellvertreter des Alleinigen Gesellschafters
und dem Notar ne varietur unterzeichnet wurde.

<i>Dritter Beschluss

Der Alleinige Gesellschafter beschließt, den Nennwert der Gesellschaftsanteile auf je einen Dollar der Vereinigten

Staaten (1,- USD) festzulegen.

175919

L

U X E M B O U R G

Der Alleinige Gesellschafter beschließt, die Anzahl der Gesellschaftsanteile auf drei Millionen vierhundert sieben und

vierzig tausend zweihundert zwei und dreißig (3.447.232) festzulegen, jede mit einem Nennwert von einem Dollar der
Vereinigten Staaten (1,- USD), anstelle der existierenden neunzehn tausend neunhundert sieben und neunzig (19.997),
jede, mit einem Nennwert von einhundertfünfundzwanzig Euro (125,- EUR).

<i>Vierter Beschluss

Die vorangehenden Beschlüsse haben zur Folge, dass der Alleinige Gesellschafter beschließt, Artikel 5.1 der Statuten

zu ändern, sodass der betreffende Teil von nun an wie folgt lautet:

“ 5.1. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt drei Millionen vierhundert sieben und vierzig tausend zweihundert

zwei und dreißig Dollar der Vereinigten Staaten (USD 3.447.232,-), bestehend aus drei Millionen vierhundert sieben und
vierzig tausend zweihundert zwei und dreißig (3.447.232) Gesellschaftsanteilen mit je einem Nennwert von einem Dollar
der Vereinigten Staaten (USD 1,-), alle eingezeichnet und gänzlich abbezahlt.”

<i>Funfter Beschluss

Der Alleinige Gesellschafter beschließt, die Bücher und Register der Gesellschaft zu ändern, um die obigen Verände-

rungen zu tragen und jedem Geschäftsführer der Gesellschaft Vertretungsmacht zu verleihen um alleinig, mit uneinge-
schränkte  Ersatzmacht,  im  Namen  der  Gesellschaft,  die  Registrierung  der  vorgenannten  Veränderungen  in  den
betreffenden Büchern und Registern der Gesellschaft vorzunehmen.

<i>Kosten

Alle Ausgaben, Kosten Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, die, infolge dieser Urkunde, durch das Unter-

nehmen getragen werden müssen, werden auf ungefähr eintausend fünfhundert Euro (EUR 1.500,-) geschätzt.

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar, welcher die englische Sprache spricht und versteht, erklärt hiermit auf Anfrage der er-

schienenen Partei, dass die Urkunde in Englisch, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, verfasst wurde, und dass im
Falle einer Abweichung, die englische Fassung maßgeblich sein soll.

Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen in Luxembourg, am Datum wie eingangs erwähnt wurde..
Das Dokument wurde dem Vertreter der Erschienenen vorgelesen, der letztere unterzeichnete zusammen mit uns,

dem Notar, die vorliegende Urkunde.

Gezeichnet: R. GALIOTTO und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 octobre 2014. Relation: LAC/2014/47159. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - Der Gesellschaft auf Begehr erteilt.

Luxemburg, den 4. November 2014.

Référence de publication: 2014171402/139.
(140195614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2014.

8F Leasing S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1748 Findel, 8, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 165.176.

Ce dépôt remplace le dépôt enregistré à Luxembourg et déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Lu-

xembourg le 30/10/2014 sous la référence L140192564.

<i>Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 24 octobre 2014

Monsieur Richard FORSON, né le 28 janvier 1962 en Afrique du Sud (Afrique du Sud), demeurant à 2, am Suebelwée,

L-5423 Sandweiler (Luxembourg), a été nommé administrateur de catégorie A jusqu'à l'issue de l'assemblée générale
statutaire de 2015.

Luxembourg, le 6 novembre 2014.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour <i>8F LEASING S.A.
United International Management S.A.

Référence de publication: 2014172515/17.
(140196610) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2014.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

175920


Document Outline

8F Leasing S.A.

ArcelorMittal

ArcelorMittal

Bravida HoldCo S.à r.l.

CC Global Investments Master Fund

Ceasar International S.à.r.l.

Centre Chretien-Social du Sud

H'Corp

Iceberg International S.à r.l.

Iena Participations S.à r.l.

Immo-Ardennes s.à.r.l.

Incentive Travel International S.à r.l.

Inteclux Software Engineering S.A.

Intercontinental Group for Commerce Industry and Finance S.A., SPF

International Brands Promotion S.A.

International Equity Investors S.A.

International Fair Consulting S.A.

International Investments Corporation S.à r.l.

International Radio Networks Holding S.A.

IRERE Property Investments (French Offices)

Isel S.à r.l.

Ixora Developpement S.A.

Josephine S.A.

Just-eat.lu S.à r.l.

KA Communications Sàrl

Kaloo S.à r.l.

Kauri Broadway Properties S.à r.l.

Kelapa Capital

KLS SPF S.A.

KWL S. à r.l.

Lord's Walk S.à r.l.

Lubex Luxembourg S.A.

Lubex Luxembourg S.A.

Lux 48 Starlight GBP S.à r.l.

Lux Flex

LuxTram S.A.

Lyxor Titrisation 1

Montblanc Management S.à r.l.

Nido London Properties S.à r.l.

Open Eyes Invest S. à r.l.

Petroleum Services Properties S.A.

Preafin III S.à r.l.

Trial Quatre S.à r.l.

Vemainvest S.A.-SPF

Willemite Investments S.A.

Wodalux S.A.

Wolmar Investments S. à r.l.