logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 3585

27 novembre 2014

SOMMAIRE

26 Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

172035

4 Pat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

172035

6922767 Holding Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

172037

Actic International S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

172036

Acti-Medic S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

172037

Addyx  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

172036

Adis S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

172036

Adis S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

172037

AI Alu (Luxembourg) Holding S.à r.l.  . . . .

172037

Aigle Aviation S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

172034

Aigle Aviation S.à r.l. & Cie, SECS  . . . . . . .

172034

Alphabeta 3 International S.à r.l.  . . . . . . . .

172034

Altice France S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

172035

Aon Holdings Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . .

172037

ArcelorMittal Energy S.C.A.  . . . . . . . . . . . .

172034

Avenue Foch Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

172035

Avenue Foch S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

172035

Aviva Investor EBC S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

172036

Aviva Investors Polish Retail S.à r.l.  . . . . . .

172036

ITELCO Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

172040

JOY OF DURABLE VALUES en abrégé

JDV SARL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

172040

K Beta S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

172040

K&D Development  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

172039

K-Group Engineering S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

172040

Le Fond et la Forme S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

172040

Lungo Mare S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

172071

MCT Berlin Vier S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

172074

MCT Berlin Zwei S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

172076

Phoenix III Mixed R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

172059

Phoenix III Mixed U  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

172053

Phoenix II Mixed L  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

172065

P.M.E Invest S.A.-SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

172078

Project Blue S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

172041

Rita's Barber Shop Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . .

172038

Rome Intermediate Holdings S. à r.l.  . . . .

172038

Royal Media Group S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

172080

RP Kosmoscenter S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

172038

RP Medicentre S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

172039

RP Ruegen S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

172039

RP Schwedt S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

172039

RP Waldstadt S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

172039

Saffron Lux HoldCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

172080

Selena Luxco S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

172038

Shinkin Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

172038

Station FRANCO S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

172080

Synplants Marketing SA  . . . . . . . . . . . . . . . .

172065

Zentralux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

172034

172033

L

U X E M B O U R G

Alphabeta 3 International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3364 Leudelange, 1, rue de la Poudrerie.

R.C.S. Luxembourg B 185.359.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n°69601 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014173405/10.
(140199357) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.

ArcelorMittal Energy S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1160 Luxembourg, 24-26, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 162.754.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 10 novembre 2014.

Référence de publication: 2014173418/10.
(140199124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.

Aigle Aviation S.à r.l. & Cie, SECS, Société en Commandite simple.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 110.579.

Le Bilan au 31.12.2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014173399/10.
(140198748) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.

Aigle Aviation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 110.578.

Le Bilan au 31/12/2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014173398/10.
(140198925) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.

Zentralux S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 93.297.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Par jugement du 08.10.2014, le Tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale a déclaré

close pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société anonyme ZENTRALUX SA, ayant eu son siège social
à L-9964 Huldange, 17 Op d'Schleid, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 93297.

Le même jugement a donné décharge au liquidateur.

Pour extrait conforme
Me Claude SPEICHER
<i>Le liquidateur / Avocat à la Cour

Référence de publication: 2014173370/14.
(140197603) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2014.

172034

L

U X E M B O U R G

26 Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 120.962.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour 26 Investments S.A.

Référence de publication: 2014173371/10.
(140197813) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2014.

4 Pat, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4490 Belvaux, 27, rue de l'Usine.

R.C.S. Luxembourg B 162.879.

Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014173372/10.
(140197282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2014.

Avenue Foch Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 177.819.

Le Bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 novembre 2014.

Signature.

Référence de publication: 2014173427/10.
(140199447) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.

Avenue Foch S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 177.894.

Le Bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 novembre 2014.

Signature.

Référence de publication: 2014173428/10.
(140199296) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.

Altice France S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 135.296.

<i>Extrait des résolutions prises par l'actionnaire unique de la société en date du 30 septembre 2014

1. L'Actionnaire unique décide de renouveler le mandat des administrateurs jusqu'à l'issue de l'assemblée générale de

la Société devant se prononcer sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social clos au 31 décembre 2014.

2. L'Actionnaire unique décide de renouveler le mandat du Réviseur d'entreprises agréé jusqu'à l'issue de l'assemblée

générale de la Société devant se prononcer sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social clos au 31 décembre
2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014173406/14.
(140198625) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.

172035

L

U X E M B O U R G

Aviva Investors Polish Retail S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.262.500,00.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 16, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 111.663.

Le bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A Luxembourg, le 10 novembre 2014.

Référence de publication: 2014173430/10.
(140199376) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.

Aviva Investor EBC S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 125.000,00.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 16, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 140.938.

Le bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A Luxembourg, le 10 novembre 2014.

Référence de publication: 2014173429/10.
(140199411) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.

Addyx, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 170.091.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 novembre 2014.

Référence de publication: 2014173437/10.
(140198735) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.

Actic International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3364 Leudelange, 1, rue de la Poudrerie.

R.C.S. Luxembourg B 167.116.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 69600 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014173397/10.
(140198661) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.

Adis S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2561 Luxembourg, 103, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 51.913.

Le bilan au 31.12.2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 novembre 2014.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L - 1013 Luxembourg

Référence de publication: 2014173438/14.
(140199402) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.

172036

L

U X E M B O U R G

Acti-Medic S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4243 Esch-sur-Alzette, 56, rue Jean-Pierre Michels.

R.C.S. Luxembourg B 93.342.

Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014173435/10.
(140198510) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.

Aon Holdings Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 168.685.

Le Bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

AON Holdings Luxembourg S.à r.l.

Référence de publication: 2014173409/10.
(140198674) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.

6922767 Holding Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 136.792.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 03 novembre 2014.

Référence de publication: 2014173375/10.
(140197440) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2014.

AI Alu (Luxembourg) Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 190.823.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 10 novembre 2014.

Référence de publication: 2014173444/10.
(140199157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.

Adis S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2561 Luxembourg, 103, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 51.913.

Le bilan au 31.12.2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 novembre 2014.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L - 1013 Luxembourg

Référence de publication: 2014173439/14.
(140199403) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.

172037

L

U X E M B O U R G

Selena Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 177.024.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 69586 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014173226/10.
(140197629) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2014.

Shinkin Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 142.391.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 novembre 2014.

Référence de publication: 2014173227/10.
(140197314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2014.

Rita's Barber Shop Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9964 Huldange, 15, op d'Schleid.

R.C.S. Luxembourg B 96.946.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014173209/10.
(140198033) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2014.

RP Kosmoscenter S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 124.841.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014173213/10.
(140198169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2014.

Rome Intermediate Holdings S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 136.187.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 Mai 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 Novembre 2014.

Rome Intermediate Holdings S.à.r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
<i>Gérant B

Référence de publication: 2014173198/14.
(140197453) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2014.

172038

L

U X E M B O U R G

RP Schwedt S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 124.737.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014173217/10.
(140198201) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2014.

RP Ruegen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 130.322.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014173216/10.
(140198192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2014.

RP Medicentre S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 124.837.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014173214/10.
(140198182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2014.

RP Waldstadt S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 124.713.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014173218/10.
(140198218) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2014.

K&amp;D Development, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof, 4, rue d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 189.439.

EXTRAIT

Les associés Monsieur Seydou Badian KANTE et Madame Salimata DEYA, détenteurs respectivement de cent (100)

parts et vingt-cinq (25) parts de la Société, ont transféré la totalité de leurs parts sociales soit cent vingt-cinq (125) parts
sociales à la société Y.K.L. HOLDING S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 4,
Grand-Rue, L-1660 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B-189.865 à la date du 3 novembre 2014.

Luxembourg, le 06 novembre 2014.

Référence de publication: 2014172987/14.
(140197781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2014.

172039

L

U X E M B O U R G

Le Fond et la Forme S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4027 Esch-sur-Alzette, 3, place Benelux.

R.C.S. Luxembourg B 171.483.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

PINHEIRO Samantha.

Référence de publication: 2014173013/10.
(140198125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2014.

ITELCO Luxembourg, Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 113.566.

La Fiduciaire Luxembourg Paris Genève S.A.R.L. dénonce avec effet immédiat la domiciliation du siège social de la

société ITELCO LUXEMBOURG SA (RCS n° B113.566) au 15-17, Avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg.

Luxembourg, le 7 novembre 2014.

Référence de publication: 2014172968/9.
(140198331) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2014.

JOY OF DURABLE VALUES en abrégé JDV SARL, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8833 Wolwelange, 10, rue de l'Ermitage.

R.C.S. Luxembourg B 169.897.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014172982/9.
(140198191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2014.

K-Group Engineering S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 191.565.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 novembre 2014.

Référence de publication: 2014172990/10.
(140198260) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2014.

K Beta S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 124.636.

<i>Extrait des résolutions écrites de l'actionnaire unique de la Société du 31 octobre 2014

Il résulte des résolutions écrites du 31 octobre 2014 que:
- Monsieur Fabian Sires, employé privé, ayant son adresse professionnel au 46a, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxem-

bourg, a été nommé administrateur avec effet au 1 

er

 novembre 2014 et jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire délibérant

sur les comptes annuels 2018 qui se tiendra en l'année 2019.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signé à Luxembourg, le 5 novembre 2014.

<i>Pour la Société
Cédric-Stébel

Référence de publication: 2014172986/16.
(140198226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2014.

172040

L

U X E M B O U R G

Project Blue S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 24, rue Astrid.

R.C.S. Luxembourg B 191.502.

STATUTES

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-fourth day of October, before us, Maître Marc Loesch, notary

residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

Fondo de Capital Privado Emprendimiento e Innovación SP, a private equity fund, governed by the laws of Colombia,

having its registered office at Calle 34, no. 6-65, Bogotá D.C., Colombia, with tax identification number (Número de
Identificación Tributario (NIT)) 900.598.771-1 (the Founding Shareholder),

here represented by Frank Stolz-Page, with professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given on October 23, 2014.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned

notary, shall remain attached to this notarial deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, represented as described above, has requested the undersigned notary to document the deed

of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which it deems to incorporate and
the articles of association of which shall be as follows:

ARTICLES OF ASSOCIATION

Art. 1. Definitions. In the interpretation of these articles of association unless the context otherwise indicates, the

following terms shall have the following meanings:

Articles

means these articles of association of the Company, as amended from time to time.

Board

means the board of managers of the Company, if several Managers have been appointed.

Business Day

means any day (other than a Saturday or Sunday) on which commercial banks are usually
open for business in Luxembourg.

Chairman

means the chairman of the Board from time to time.

Company

means Project Blue S.à r.l.

General Meeting

means the general meeting of the Shareholders.

Law

means the company law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended from
time to time.

Managers

means the persons appointed as such by the General Meeting and Manager means any of
them.

Shareholders

means the persons registered in the register of shareholders of the Company, in application
of article 185 of the Law, as the holders of the Shares from time to time and Shareholder
means any of them.

Shareholders Circular
Resolutions

shall have the meaning ascribed to such term in article 10.

Shares

means the shares in registered form in the share capital of the Company having a par value
of one United States Dollar (USD 1.-) each and Share means any of them.

Sole Manager

means the sole manager of the Company.

Sole Shareholder

means the sole person registered in the register of shareholders of the Company, in ap-
plication of article 185 of the Law, as the only holder of the Shares from time to time.

Art. 2. Form and Name. The name of the Company is “Project Blue S.à r.l.”. The Company is a private limited liability

company (société à responsabilité limitée) governed by the present Articles, the Law and the relevant legislation.

The Company may have a Sole Shareholder or Shareholders. Any reference to the Shareholders in the Articles shall

be a reference to the Sole Shareholder if the Company has only one (1) Shareholder.

Art. 3. Corporate Objects. The purpose of the Company is the acquisition, holding, management and disposal of

participations and any interests, in Luxembourg or abroad, in any companies and/or enterprises in any form whatsoever.
The Company may in particular acquire by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares
and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more ge-
nerally, any securities and financial instruments issued by any public or private entity. It may participate in the creation,
development, management and control of any company and/or enterprise. It may further invest in the acquisition and
management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin.

The Company may borrow in any form except by way of public offer and proceed by private placement only to the

issue of bonds, notes, debentures or any kind of debt or equity securities.

172041

L

U X E M B O U R G

The Company may lend funds, including without limitation, resulting from any borrowings of the Company and/or

from the issue of any equity or debt securities of any kind, to its subsidiaries, affiliated companies and/or any other
companies or entities it deems fit.

The Company may further guarantee, grant security in favor of or otherwise assist the companies in which it holds a

direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company. The Company may
further give guarantees, pledge, transfer or encumber or otherwise create security over some or all of its assets to
guarantee its own obligations and those of any other company, and generally for its own benefit and that of any other
company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial
sector without having obtained the required authorisation.

The Company may further act as a general or limited member with unlimited or limited liability for all debts and

obligations of partnerships or similar entities.

The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself against

credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

The Company may, for its own account as well as for the account of third parties, carry out all operations (including,

without limitation, transactions with respect to real estate or movable property) which may be useful or necessary to
the accomplishment of its purpose or which are directly or indirectly related to its purpose.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.

Art. 5. Registered Office. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the General Meeting.

Within the boundaries of the municipality of Luxembourg-City, the registered office may be transferred by a resolution
of the Board or, in the case of a sole Manager, by a decision of the Sole Manager.

The Board or, as the case may be, the Sole Manager, shall further have the right to set up branches, subsidiaries or

other offices wherever it shall deem fit, either within or outside the Grand Duchy of Luxembourg.

Where the Board or, as the case may be, the Sole Manager, determines that extraordinary political or military deve-

lopments or events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the
normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and
persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
traordinary  circumstances. Such temporary  measures shall  have no effect  on  the  nationality of  the Company which,
notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 6. Share Capital. The subscribed share capital of the Company is set at forty thousand United States Dollars (USD

40,000.-), represented by forty thousand (40,000) Shares having a par value of one United States Dollar (USD 1.-) each.

The Company's subscribed share capital may be increased or reduced by a resolution adopted by the General Meeting

in the manner required for the amendment to the Articles, as prescribed in article 11 below.

Art. 7. Shares. All Shares are in registered form, fully subscribed and entirely paid up.
A register of the Shareholders will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any

Shareholder. Such register shall set forth the name of each Shareholder, his/her/its residence or elected domicile, the
number of Shares held by him/her/it, the amounts paid in on each such Share, and the transfer/subscription of Shares and
the dates of such transfers/subscriptions as well as any security rights granted on the Shares from time to time. Each
Shareholder will notify the Company by registered letter his/her/its address and any change thereof. The Company may
rely on the last address of a Shareholder received by it. The ownership of the Shares will be established by the entry in
this register.

Certificates of these entries may be issued to the Shareholders and such certificates, if any, will be signed by the

Chairman or by any two (2) Managers or, as the case may be, the Sole Manager.

The Company will recognise only one (1) holder per Share. In case a Share is held by more than one (1) person, the

Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that Share until one (1) person has been appointed
as sole owner in relation to the Company. The same rule shall apply in the case of conflict between a usufruct holder
(usufruitier) and a bare owner (nu-propriétaire) or between a pledgor and a pledgee.

The Company may repurchase or redeem its own Shares provided that the repurchased or redeemed Shares be

immediately cancelled and the subscribed share capital of the Company reduced accordingly.

Art. 8. Transfer of Shares. Shares are freely transferable among the Shareholders. Except if otherwise provided by law,

the transfer of Shares to third parties is subject to the prior consent of the Shareholders representing at least three-
quarters  (3/4)  of  the  Company's  subscribed  share  capital.  The  transfer  of  Shares  to  third  parties  by  reason  of  a
Shareholder's death must be approved by the Shareholders representing three-quarters (3/4) of the rights owned by the
survivors.

The transfer of the Shares may be effected by a written declaration of transfer entered in the register of the Share-

holders, such declaration of transfer to be dated and executed by the transferor and the transferee or by the persons

172042

L

U X E M B O U R G

holding suitable powers of attorney or in accordance with the provisions applying to the transfer of claims provided for
in article 1690 of the Luxembourg civil code.

The Company may also accept as evidence of transfer other instruments of transfer evidencing the consent of the

transferor and the transferee satisfactory to the Company.

Art. 9. Powers of the General Meeting. As long as the Company has only one (1) Shareholder, the Sole Shareholder

assumes all powers conferred to the General Meeting. In these Articles, decisions taken, or powers exercised, by the
General Meeting shall be a reference to decisions taken, or powers exercised, by the Sole Shareholder as long as the
Company has only one (1) Shareholder. Decisions taken by the Sole Shareholder are documented by way of written
minutes.

In the case of a plurality of Shareholders, any regularly constituted General Meeting shall represent the entire body of

Shareholders. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to all the operations of the
Company.

Art. 10. Annual General Meeting - Other General Meetings. If the number of Shareholders exceeds twenty-five (25),

the annual General Meeting shall be held, in accordance with the Law, at the address of the registered office of the
Company or at such other place in the municipality of the registered office as may be specified in the convening notice
of the General Meeting, on the third Thursday in June of each year at 3 p.m. If such day is not a Business Day, the annual
General Meeting shall be held on the next following Business Day.

Notwithstanding the above, the annual General Meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of

the Board or, as the case may be, the Sole Manager, exceptional circumstances so require.

Other General Meetings may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices

of the General Meeting.

Resolutions of the Shareholders shall be adopted at a General Meeting or by way of circular resolutions (the Share-

holders Circular Resolutions) in case the number of Shareholders is less than or equal to twenty-five (25).

Where resolution(s) is/are to be adopted by way of Shareholders Circular Resolutions, each Shareholder shall be sent

an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall sign the resolution(s). Shareholders Circular Resolutions signed
by all the Shareholders shall be valid and binding as if passed at a General Meeting duly convened and held and shall bear
the date of the last signature.

Art. 11. Notice, quorum, convening notices, powers of attorney and vote. The Shareholders shall be convened to the

General Meetings or consulted in writing at the initiative of (i) any Manager or, as the case may be, the Sole Manager, (ii)
the statutory auditor (if any) or (iii) Shareholders representing more than one-half (1/2) of the Company's subscribed
share capital.

Written convening notice of any General Meeting shall be given to all Shareholders by registered mail to their address

appearing in the register of Shareholders held by the Company at least eight (8) calendar days in advance of the date of
the  General  Meeting,  except  in  case  of  emergency,  the  nature  and  circumstances  of  which  shall  be  set  forth  in  the
convening notice of the General Meeting.

If all the Shareholders are present and/or represented at a General Meeting and consider themselves as being duly

convened and informed of the agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior written convening
notice.

A Shareholder may act at any General Meeting by appointing another person, who need not be a Shareholder, as its

proxy in writing whether in original, by telefax or e-mail to which an electronic signature (which is valid under Luxembourg
law) is affixed.

Any Shareholder may participate in a General Meeting by conference call, video conference or similar means of com-

munications equipment whereby (i) all the Shareholders attending the General Meeting can be identified, (ii) all persons
participating in the General Meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the General Meeting is
performed on an on-going basis and (iv) the Shareholders can properly deliberate. Participating in a General Meeting by
such means shall constitute presence in person at such General Meeting.

Resolutions to be adopted at General Meetings shall be passed by Shareholders owning more than one-half (1/2) of

the Company's subscribed share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting, the Shareholders shall
be convened by registered letters to a second General Meeting and the resolutions shall be adopted at the second General
Meeting by a majority of the votes cast, regardless of the proportion of the subscribed share capital represented.

The Articles may be amended with the consent of a majority (in number) of Shareholders owning at least three-quarters

(3/4) of the Company's subscribed share capital.

Any change in the nationality of the Company and any increase of a Shareholder's commitment in the Company shall

require the unanimous consent of the Shareholders.

Each Share is entitled to one (1) vote at General Meetings.

Art. 12. Management. The Company shall be managed by one (1) or several Manager(s) who need not be Shareholders.

172043

L

U X E M B O U R G

The Manager(s) shall be appointed by the General Meeting. The General Meeting shall also determine the number of

Managers, their remuneration and the term of their office. A Manager may be removed with or without cause and/or
replaced, at any time, by a resolution adopted by the General Meeting.

If several Managers are appointed, they shall constitute the Board.
Where the Company is managed by a Board, each Manager shall be assigned either an A or a B signatory power.

Art. 13. Meetings of the Board. The Board shall appoint a Chairman among its members and may choose a secretary,

who need not be a Manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board, the
resolutions passed at the General Meeting or of the resolutions passed by the Sole Shareholder. The Chairman will preside
at all meetings of the Board. In his/her absence, the other Managers will appoint another Chairman pro tempore who
will preside at the relevant meeting by simple majority vote of the Managers present and/or represented at such meeting.

The Board shall meet upon call by the Chairman or any two (2) Managers at the place indicated in the convening notice

of the meeting.

Written convening notice of any meeting of the Board shall be given to all the Managers at least twenty-four (24) hours

in advance of the date set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such
circumstances shall be set forth briefly in the convening notice of the meeting of the Board.

No such written convening notice is required if all the Managers are present and/or represented during the meeting

and if they state to have been duly informed and to have had full knowledge of the agenda of the meeting. The written
convening notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telefax or e-mail to which an electronic
signature (which is valid under Luxembourg law) is affixed, of each Manager. Separate written convening notice shall not
be required for meetings that are held at times and places determined in a schedule previously adopted by a resolution
of the Board.

Any Manager may act at any meeting of the Board by appointing in writing, whether in original, by telefax or e-mail to

which an electronic signature (which is valid under Luxembourg law) is affixed, another Manager as his or her proxy.

The Board can validly debate and take decisions only if at least the majority of its members is present and/or repre-

sented. The Board can validly debate and take decisions only if at least the majority of its members is present and/or
represented and at least one (1) category A manager and at least one (1) category B manager are present and/or repre-
sented. A Manager may represent more than one of his or her colleagues, provided however that at least two (2) Managers
are present at the meeting or participate at such meeting by way of any means of communication that are permitted
under the Articles and the Law. Decisions are taken by the majority of the Managers present and/or represented. Deci-
sions are taken by the majority of the Managers present and/or represented provided that any resolution shall not validly
be passed unless it is approved by at least one (1) category A Manager and at least one (1) category B Manager.

In case of a tied vote, the Chairman of the meeting shall have a casting vote.
Any Manager may participate in a meeting of the Board by conference call, video conference or similar means of

communications equipment whereby (i) all Managers attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating
in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an on-going basis
and (iv) the Managers can properly deliberate. Participating in a meeting by such means shall constitute presence in person
at such meeting. A meeting of the Board held by such means of communication will be deemed to be held in Luxembourg.

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board may also be passed in writing, in case of urgency or where

other exceptional circumstances so require. Such written resolution shall consist of one or several documents containing
the resolution and signed, manually or electronically by means of an electronic signature (which is valid under Luxembourg
law) by each Manager. The date of such resolution shall be the date of the last signature.

Article 13 does not apply in the case that the Company is managed by a Sole Manager.

Art. 14. Minutes of meetings of the Board or minutes of resolutions of the Sole Manager. The resolutions passed by

the Sole Manager shall be documented by written minutes kept at the Company's registered office.

The minutes of any meeting of the Board shall be signed by the Chairman or a member of the Board who presided at

such meeting or all the Managers present at such meeting. The minutes of the resolutions taken by the Sole Manager shall
be signed by the Sole Manager.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the

Chairman, any two (2) Managers or the Sole Manager (as the case may be).

Art. 15. Powers of the Board. The Board or, as the case may be, the Sole Manager is vested with the broadest powers

to manage the business of the Company and to authorise and/or perform or cause to be performed all acts of disposal
and administration falling within the corporate objects of the Company.

All powers not expressly reserved by the Law or by the Articles to the General Meeting fall within the competence

of the Board or, as the case may be, the Sole Manager.

Art. 16. Delegation of powers. The Board may appoint a person (délégué à la gestion journalière), either a Shareholder

or not, or a member of the Board or not, who shall have full authority to act on behalf of the Company in all matters
concerned with the daily management and affairs of the Company.

172044

L

U X E M B O U R G

The Board may appoint a person, either a Shareholder or not, either a Manager or not, as permanent representative

for any entity in which the Company is appointed as member of the board of directors. This permanent representative
shall act with all discretion, but in the name and on behalf of the Company, and may bind the Company in its capacity as
member of the board of directors of any such entity.

The Board is also authorised to appoint a person, either Manager or not, for the purposes of performing specific

functions at every level within the Company.

Art. 17. Binding signatures. The Company shall be bound towards third parties in all matters by (i) the joint signatures

of at least one (1) category A Manager and at least one (1) category B Manager or as the case may be, (ii) the sole signature
of the Sole Manager.

The Company shall further be bound by the joint signatures of any persons or the sole signature of the person to

whom specific signatory power has been granted by the Board or the Sole Manager, but only within the limits of such
power. Within the boundaries of the daily management, the Company will be bound by the sole signature, as the case
may be, of the person appointed to that effect in accordance with the first paragraph of article 16 above.

Art. 18. Liability of the Manager(s). The Manager(s) do not assume, by reason of their position, any personal liability

in relation to commitments regularly made by them in the name of the Company provided such commitments comply
with the Articles and the Law. They are authorised agents only and are therefore merely responsible for the execution
of their mandate.

Art. 19. Audit. If the number of Shareholders exceeds twenty-five (25), the operations of the Company shall be su-

pervised by one (1) or more statutory auditor(s) (commissaire(s) aux comptes), or, where required by the Law, an
independent external auditor (réviseur d'entreprises agréé).

The Shareholders shall appoint the statutory auditor(s) (commissaire(s) aux comptes), if any and the independent

external auditor (réviseur d'entreprises agréé), if any, and determine their number, remuneration and the term of their
office, which may not exceed six (6) years. The statutory auditor(s) (commissaire(s) aux comptes) and the independent
external auditor (réviseur d'entreprises agréé) may be re-appointed.

Art. 20. Accounting Year. The accounting year of the Company shall begin on January first (1 

st

 ) and ends on December

thirty-first (31 

st

 ) of each year.

Art. 21. Annual Accounts. Every year as of the accounting year's end, the Board or, as the case may be, the Sole

Manager will draw up the annual accounts of the Company in the form required by the Law.

Each Shareholder may inspect the above inventory and annual accounts at the Company's registered office.

Art. 22. Distributions. From the annual net profits of the Company, five percent (5%) shall be allocated to the reserve

required by law. This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to ten percent (10%) of
the subscribed share capital of the Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in article
6 above, but shall again be compulsory if the reserve falls below such one-tenth (1/10).

The annual General Meeting shall determine the allocation of the remainder of the annual net profits and may decide

to pay dividends from time to time as in its discretion it believes best suits the corporate purpose and policy and within
the limits of the Law.

Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) interim accounts are drawn up by the Board or, as the case may be, the Sole Manager;
(ii) such interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premiums) are available for

distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last
accounting year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and
distributable reserves, and decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal reserve;

(iii) the Company's auditor, if any, has stated in his/her report to the Board or, as the case may be, the Sole Manager,

that items (i) and (ii) above have been satisfied;

(iv) the decision to distribute interim dividends must be taken by the Shareholders or the Board, or as the case may

be, the Sole Manager, within two (2) months from the date of the interim accounts;

(v) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company; and
(vi) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the accounting year, the Shareholders

must refund the excess to the Company.

Art. 23. Dissolution.  The  Company  is  not  dissolved  by  reason  of  the  death,  suspension  of  civil  rights,  incapacity,

bankruptcy, insolvency or any similar event affecting one (1) or several Shareholders.

The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting adopted in the manner required

for the amendment to the Articles, as prescribed in article 11 above. In the event of a dissolution of the Company, the
liquidation shall be carried out by one (1) or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed
by the General Meeting deciding such liquidation. Such General Meeting shall also determine the powers and the remu-
neration of the liquidator(s).

172045

L

U X E M B O U R G

The surplus, after realization of the assets and the payment of the liabilities, shall be distributed among the Shareholders

proportionally to the Shares held by them.

Art. 24. Applicable law. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with

the Law and, subject to any non-waivable provisions of the applicable law, any agreement entered into by the Shareholders
from time to time.

<i>Transitional provision

The first accounting year begins today and ends on December thirty-first (31 

st

 ), 2014.

<i>Subscription and payment

The Articles having thus been established, the Founding Shareholder, represented as described above, hereby declares

that it subscribes to forty thousand (40,000) shares representing the total subscribed share capital of the Company.

All these shares have been fully paid up by the Founding Shareholder by a payment in cash, so that the sum of forty

thousand United States Dollars (USD 40,000.-) paid by the Founding Shareholder is from now on at the free disposal of
the Company, evidence thereof having been given to the officiating notary.

<i>Statement - Costs

The notary executing this notarial deed declares that the conditions prescribed by articles 182 and 183 of the Law

have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment. Further, the notary executing this deed confirms that
these Articles comply with the provisions of articles 27 and 184 of the Law.

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately one thousand four hundred Euro (EUR 1,400).

<i>Resolutions of the sole shareholder

The Founding Shareholder, represented as described above, representing the total subscribed share capital of the

Company, has passed the following resolutions:

(a) the number of managers of the Company is set at four (4);
(b) the following persons are appointed as managers of the Company having an A signatory power:
- Jaime Cepeda López, economist, born on January 26, 1963, in Bogotá, Colombia whose professional address is at

Street 34 # 6 - 65, Bogotá, Colombia; and

- Felipe Zárate Gutierrez, civil engineer, born on December 7, 1970 in Bogotá, Colombia, whose professional address

is at Carrera 43 A # 1 sur 100, Piso 12, Edificio Sudameris, Medellin, Colombia 050010.

and the following persons are appointed as managers of the Company having a B signatory power:
- Xavier Soulard, director, born on August 14, 1980, in Chateauroux, France, whose professional address is at 24, rue

Astrid, L-1143 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and

- Philippe Toussaint, director, born on September 2, 1975, in Arlon, Belgium, whose professional address is at 10A,

rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

(c) that the members of the Board are appointed for an undetermined period; and
(d) that the address of the registered office of the Company is set at 24, rue Astrid, L-1143 Luxembourg, Grand Duchy

of Luxembourg.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the proxyholder

of the above appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the
same proxyholder and in case of divergences between the English and the French versions, the English version will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Mondorf-les-Bains, at the office of the undersigned notary, on

the day named at the beginning of this document.

This document having been read to the proxyholder of the appearing party, who is known to the undersigned notary

by his/her surname, name, civil status and residence, the said proxyholder of the appearing party signed the present deed
together with the undersigned notary.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le vingt-quatrième jour du mois d'octobre,
par devant nous, Maître Marc Loesch, notaire demeurant à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu:

Fondo de Capital Privado Emprendimiento e Innovaciòn SP, un fond d'investissement privé régi par les lois de Colombie,

ayant son siège social à Calle 34, no. 6-65, Bogota D.C., Colombie, dont le numéro d'identification fiscal (Número de
Identificación Tributario (NIT)) est le 900.598.771-1 (l'Associé Fondateur),

ici représentée par Frank Stolz-Page, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

172046

L

U X E M B O U R G

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 23 octobre 2014.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante ainsi que par le notaire

soussigné, restera annexée au présent acte notarié pour être soumise ensemble aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante, représentée tel que décrit ci-dessus, a requis le notaire soussigné d'enregistrer l'acte de

constitution d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer et de dresser les statuts qu'elle a arrêtés
comme suit:

STATUTS

Art. 1 

er

 . Définitions.  Pour ce qui est de l'interprétation de ces statuts, à moins que le contexte ne l'indique de manière

différente, les termes suivants auront les significations suivantes:

Assemblée Générale

signifie l'assemblée générale des Associés.

Associés

signifie les personnes nommées dans le registre des associés de la Société, conformément
à l'article 185 de la Loi, en tant que détenteurs de Parts Sociales de temps à autre et Associé
signifie n'importe lequel d'entre eux.

Associé Unique

signifie la personne unique nommée dans le registre des associés de la Société,
conformément à l'article 185 de la Loi, en tant que seul détenteur des Parts Sociales de
temps à autre.

Conseil

signifie l'organe de gérance de la Société, si plusieurs Gérants ont été nommés.

Gérants

signifie les personnes nommées en cette qualité par l'Assemblée Générale et Gérant signifie
n'importe lequel d'entre eux.

Gérant Unique

signifie le gérant unique de la Société.

Jour Ouvrable

signifie toute journée (autre qu'un samedi ou un dimanche) pendant laquelle les banques
commerciales sont normalement ouvertes au public au Luxembourg.

Loi

signifie la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée de temps
à autre.

Parts Sociales

signifie les parts sociales nominatives dans le capital social de la Société ayant une valeur
nominale d'un Dollar des Etats-Unis (USD 1,-) chacune et Part Sociale signifie n'importe
laquelle d'entre elles.

Président

signifie le président du Conseil de temps à autre.

Résolutions Circulaires
des Associés

aura la signification donnée à ce terme à l'article 10.

Société

signifie Project Blue S.à r.l.

Statuts

signifie les présents statuts de la Société tels que modifiés de temps à autre.

Art. 2. Forme et Dénomination. La dénomination de la Société est "Project Blue S.à r.l.". La Société est une société à

responsabilité limitée gouvernée par les présents Statuts, la Loi et la législation applicable.

La Société peut avoir un Associé Unique ou des Associés. Toute référence aux Associés dans les Statuts est une

référence à l'Associé Unique si la Société n'a qu'un seul Associé.

Art. 3. Objet Social. L'objet de la Société est l'acquisition, la détention, la gestion et la disposition de participations ou

d'intérêts, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit. La
Société peut notamment acquérir par souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et
autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généra-
lement, toutes valeurs et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création,
au développement, à la gestion et au contrôle de toute société et/ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acqui-
sition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine
que ce soit.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit excepté par voie d'offre publique et elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l'émission d'obligations, de billets à ordre, de titres de créance ou de toute
sorte de créance ou de titres participatifs.

La Société peut prêter des fonds comprenant, sans limitation, ceux résultant de ses emprunts et/ou des émissions de

titres participatifs ou de titres de créance de toute sorte, à ses filiales, à des sociétés affiliées et à toutes autres sociétés
et/ou entités jugées appropriées.

La Société peut également garantir, accorder des garanties à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle

détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.
La Société peut en outre consentir des garanties, nantir, céder ou grever de charge ou créer, de toute autre manière,
des sûretés portant sur tout ou partie de ses avoirs pour garantir ses propres obligations et celles de toute autre société,
généralement pour son propre bénéfice et celui de toute autre société ou personne. Pour éviter toute ambiguïté, la
Société ne peut pas exercer d'activités réglementées du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation requise.

172047

L

U X E M B O U R G

La Société peut encore agir en tant qu'associé commandité ou commanditaire avec responsabilité illimitée ou limitée

pour toutes les créances et obligations de sociétés en commandite (partnership) ou entités similaires.

La Société peut employer toutes techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investissements,

y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques liés aux crédits, aux fluctuations mo-
nétaires, aux fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

La Société peut, pour son propre compte ainsi que pour le compte de tiers, accomplir toutes les opérations (com-

prenant, sans limitation, des transactions mobilières et immobilières) utiles ou nécessaires à l'accomplissement de son
objet social ou se rapportant directement ou indirectement à celui-ci.

Art. 4. Durée de la Société. La Société est formée pour une période indéterminée.

Art. 5. Siège Social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville.
Il pourra être transféré vers toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l'Assemblée

Générale. Dans les limites de la commune de Luxembourg-Ville, le siège social peut être transféré par une résolution du
Conseil ou, dans le cas d'un Gérant unique, par une décision du Gérant Unique.

Le Conseil ou, le cas échéant, le Gérant Unique, a encore le droit de créer des succursales, des filiales ou d'autres

bureaux en tous lieux qu'il jugera appropriés, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Lorsque le Conseil ou, le cas échéant, le Gérant Unique estime que des événements extraordinaires d'ordre politique

ou militaire de nature à compromettre l'activité normale de la Société au siège social, ou la communication aisée entre
le siège social de la Société et l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer temporairement le siège
social de la Société à l'étranger jusqu'à la cessation complète de ces circonstances extraordinaires. Ces mesures tempo-
raires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, en dépit du transfert temporaire de son siège
social, restera une société luxembourgeoise.

Art. 6. Capital Social. Le capital social souscrit de la Société est fixé à quarante mille Dollars des Etats-Unis (USD

40.000,-), représenté par quarante mille (40.000) Parts Sociales ayant une valeur nominale d'un Dollar des Etats-Unis
(USD 1,-) chacune.

Le capital social souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution prise par l'Assemblée Générale

statuant de la manière requise en cas de modification des Statuts, dans les conditions prévues à l'article 11 ci-dessous.

Art. 7. Parts Sociales. Toutes les Parts Sociales sont nominatives, pleinement souscrites et entièrement libérées.
Un registre des Associés est tenu au siège social, où il peut être consulté par tout Associé. Ce registre contient le

nom de tout Associé, sa résidence ou son domicile élu, le nombre de Parts Sociales qu'il détient, le montant libéré pour
chacune de ses Parts Sociales, ainsi que la mention des cessions/souscriptions de Parts Sociales et les dates de ces cessions/
souscriptions ainsi que toutes garanties accordées sur les Parts Sociales de temps à autre. Chaque Associé notifiera son
adresse à la Société par lettre recommandée, ainsi que tout changement d'adresse ultérieur. La Société peut considérer
comme exacte la dernière adresse de l'Associé qu'elle a reçue. La propriété des Parts Sociales est établie par inscription
dans ledit registre.

Des certificats constatant ces inscriptions peuvent être émis aux Associés et ces certificats, s'ils sont émis, seront

signés par le Président ou par deux (2) Gérants ou, le cas échéant, par le Gérant Unique.

La Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par Part Sociale. Dans le cas où une Part Sociale viendrait à appartenir

à plusieurs personnes, la Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous droits attachés à cette Part Sociale jusqu'au
moment où une (1) personne aura été désignée comme propriétaire unique vis-à-vis de la Société. La même règle sera
appliquée en cas de conflit entre un usufruitier et un nu-propriétaire ou entre un créancier et un débiteur gagiste.

La Société peut racheter ou retirer ses propres Parts Sociales à condition d'annuler immédiatement les Parts Sociales

rachetées ou retirées et d'une réduction du capital social souscrit de la Société correspondante.

Art. 8. Cessions de Parts Sociales. La cession de Parts Sociales entre Associés peut se faire librement. A moins que la

loi ne le prévoie autrement, la cession de Parts Sociales à des tiers est soumise à l'accord préalable des Associés repré-
sentant au moins trois-quarts (3/4) du capital social souscrit de la Société. La cession de Parts Sociales à des tiers en
raison du décès d'un Associé doit être approuvée par les Associés représentant trois-quarts (3/4) des droits détenus par
les survivants.

La cession de Parts Sociales peut s'effectuer par une déclaration écrite de la cession inscrite au registre des Associés,

cette déclaration de cession devant être datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par des personnes détenant
les pouvoirs de représentation nécessaire pour agir à cet effet ou, conformément aux dispositions de l'article 1690 du
code civil luxembourgeois relatives à la cession de créances.

La Société peut également accepter comme preuve de cession d'autres instruments de cession prouvant les consen-

tements du cédant et du cessionnaire, et jugés suffisants par la Société.

Art. 9. Pouvoirs de l'Assemblée Générale. Aussi longtemps que la Société n'a qu'un (1) Associé, l'Associé Unique a

tous les pouvoirs conférés à l'Assemblée Générale. Dans ces Statuts, toute référence aux décisions prises ou aux pouvoirs
exercés par l'Assemblée Générale est une référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Associé Unique

172048

L

U X E M B O U R G

tant que la Société n'a qu'un (1) seul Associé. Les décisions prises par l'Associé Unique sont enregistrées par voie de
procès-verbaux écrits.

Dans l'hypothèse d'une pluralité d'Associés, toute Assemblée Générale régulièrement constituée représente tous les

Associés. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société.

Art. 10. Assemblée Générale annuelle - Autres Assemblées Générales. Si le nombre d'Associés excède vingt-cinq (25),

l'Assemblée Générale annuelle se tient conformément à la Loi à l'adresse du siège social de la Société ou à tout autre
endroit de la commune du siège social indiqué dans les convocations de l'Assemblée Générale, le troisième jeudi de
chaque année à 13.00 heures. Si ce jour n'est pas un Jour Ouvrable, l'Assemblée Générale annuelle se tiendra le premier
Jour Ouvrable suivant.

Nonobstant ce qui précède, l'Assemblée Générale annuelle peut se tenir à l'étranger si le Conseil ou, le cas échéant,

le Gérant Unique, constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

Les autres Assemblées Générales pourront se tenir aux lieu et heure spécifiés dans les avis de convocation.
Les résolutions des Associés seront prises par l'Assemblée Générale ou par voie de résolutions circulaires (les Réso-

lutions Circulaires des Associés) dans le cas où le nombre des Associés est inférieur ou égal à vingt-cinq (25).

Lorsque la (les) résolution(s)doivent/doit être prise(s) par le biais de Résolutions Circulaires des Associés, chaque

Associé recevra un projet de la (des) résolution(s) à passer, et signera la (les) résolution(s). Les Résolutions Circulaires
des Associés signées par tous les Associés seront valides et engageront la Société comme si elles avaient été prises pendant
une Assemblée Générale dûment convoquée et tenue et porteront la date de la dernière signature.

Art. 11. Convocation, quorum, avis de convocation, procurations et vote. Les Associés sont convoqués aux Assemblées

Générales ou consultés par écrit à l'initiative (i) de tout Gérant ou, le cas échéant, du Gérant Unique, (ii) du/des com-
missaire(s) aux comptes le cas échéant ou (iii) d'Associés représentant plus de la moitié (1/2) du capital social souscrit
de la Société.

Les avis de convocation pour toute Assemblée Générale sont envoyés à tous les Associés par lettre recommandée à

leur domicile dont il est fait mention dans le registre des Associés tenu par la Société au moins huit (8) jours calendaires
avant la date de l'Assemblée Générale, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation.

Si tous les Associés sont présents et/ou représentés à une Assemblée Générale, et déclarent avoir été dûment con-

voqués et informés de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, l'Assemblée Générale pourra être tenue sans convocation
préalable.

Chaque Associé peut prendre part aux Assemblées Générales en désignant par écrit, soit en original, soit par téléfax

ou par courriel muni d'une signature électronique (conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise), une autre per-
sonne comme mandataire, Associé ou non.

Tout Associé peut participer à une Assemblée Générale par conférence téléphonique, vidéo conférence ou tout autre

moyen de communication similaire grâce auquel (i) tous les Associés participant à l'Assemblée Générale peuvent être
identifiés, (ii) toute personne participant à l'Assemblée Générale peut entendre les autres participants et leur parler, (iii)
l'Assemblée Générale est retransmise en direct et (iv) les Associés peuvent valablement délibérer. La participation à une
Assemblée Générale par un tel moyen de communication équivaudra à une participation en personne à l'Assemblée
Générale.

Les Résolutions devant être adoptées en Assemblées Générales seront prises par les Associés détenant plus de la

moitié (1/2) du capital social souscrit de la Société. Si cette majorité n'est pas atteinte lors de la première Assemblée
Générale, les Associés seront convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée Générale et les résolutions
seront prises lors de la seconde Assemblée Générale à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion
du capital social souscrit représenté.

Les Statuts peuvent être modifiés avec le consentement d'une majorité (en nombre) d'Associés détenant au moins

trois-quarts (3/4) du capital social souscrit de la Société.

Le changement de la nationalité de la Société et l'augmentation des engagements d'un Associé dans la Société exigent

l'accord unanime des Associés.

Chaque Part Sociale donne droit à un (1) vote aux Assemblées Générales.

Art. 12. Administration. La Société est administrée par un (1) ou plusieurs Gérant(s), Associés ou non.
Le(s) Gérant(s) est (sont) nommé(s) par l'Assemblée Générale. L'Assemblée Générale détermine également le nombre

de Gérants, leur rémunération et la durée de leur mandat. Un Gérant peut être révoqué avec ou sans motif et/ou remplacé,
à tout moment, par une résolution prise par l'Assemblée Générale.

Si plusieurs Gérants sont nommés, ceux-ci constitueront le Conseil.
Si la Société est administrée par un Conseil, chaque Gérant se verra attribué soit un pouvoir de signature A, soit un

pouvoir de signature B.

172049

L

U X E M B O U R G

Art. 13. Réunion du Conseil. Le Conseil doit nommer un Président parmi ses membres et peut désigner un secrétaire,

Gérant ou non, qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil, des résolutions passées en
Assemblée Générale ou des résolutions passées par l'Associé Unique. Le Président préside toutes les réunions du Conseil.
En son absence, les autres Gérants nommeront un autre Président pro tempore qui présidera la réunion en question par
un vote à la majorité simple des Gérants présents et/ou représentés à la réunion en question.

Les réunions du Conseil sont convoquées par le Président ou par deux (2) Gérants, au lieu indiqué dans l'avis de

convocation de la réunion.

Avis écrit de toute réunion du Conseil est donné à tous les Gérants au moins vingt-quatre (24) heures avant la date

prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
brièvement dans la convocation de la réunion du Conseil.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les Gérants sont présents et/ou représentés

lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé
à la convocation écrite avec l'accord de chaque Gérant donné par écrit soit en original, soit par téléfax ou par courriel
muni d'une signature électronique (conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise). Une convocation spéciale ne sera
pas requise pour une réunion se tenant aux lieu et place prévus dans une résolution préalablement prise par le Conseil.

Tout Gérant peut se faire représenter lors d'une réunion du Conseil en désignant par écrit soit en original, soit par

téléfax ou par courriel muni d'une signature électronique (conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise), un autre
Gérant comme son mandataire.

Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité au moins de ses membres est présente et/ou

représentée. Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité au moins de ses membres est présente
et/ou représentée et au moins un (1) Gérant de catégorie A et au moins un (1) Gérant de catégorie B est présent et/ou
représenté. Un Gérant peut représenter plus d'un de ses collègues, à condition que deux (2) Gérants au moins soient
présents à la réunion ou y participent par un moyen de communication qui est autorisé par les Statuts ou par la Loi. Les
décisions sont prises à la majorité des voix des Gérants présents et/ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité
des voix des Gérants présents et/ou représentés sous réserve qu'une résolution ne sera pas valablement prise sans être
approuvée par au moins un (1) Gérant de catégorie A et au moins un (1) Gérant de catégorie B.

Au cas où lors d'une réunion, il existe une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du Président de la

réunion sera prépondérante. Tout Gérant peut participer à la réunion du Conseil par conférence téléphonique, vidéo
conférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) tous les Gérants participant à la réunion
peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion peut entendre les autres participants et leur parler,
(iii) la réunion est retransmise en direct et (iv) les Gérants peuvent valablement délibérer. La participation à une réunion
par un tel moyen de communication équivaudra à une participation en personne à une telle réunion. Une réunion du
Conseil qui se tient par le biais de tels moyens de communication sera considérée comme s'étant tenue au Luxembourg.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles le justifiant, une

résolution du Conseil peut également être prise par écrit. Une telle résolution doit consister en un seul ou plusieurs
documents contenant les résolutions et signés, manuellement ou électroniquement par une signature électronique (con-
forme aux exigences de la loi luxembourgeoise) par tous les Gérants. La date d'une telle résolution est la date de la
dernière signature.

L'article 13 ne s'applique pas dans le cas où la Société est administrée par un Gérant Unique.

Art. 14. Procès-verbaux de réunions du Conseil et Procès-verbaux des résolutions du Gérant Unique. Les résolutions

prises par le Gérant Unique sont inscrites dans des procès-verbaux tenus au siège social de la Société.

Les procès-verbaux des réunions du Conseil sont signés par le Président ou un membre du Conseil qui en aura assumé

la présidence ou par tous les Gérants ayant assisté à la réunion. Les procès-verbaux des résolutions prises par le Gérant
Unique sont signés par le Gérant Unique.

Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs sont signés par le Président, deux (2)

Gérants ou le Gérant Unique (le cas échéant).

Art. 15. Pouvoirs du Conseil. Le Conseil ou, le cas échéant, le Gérant Unique est investi des pouvoirs les plus larges

pour gérer les affaires de la Société et autoriser et/ou exécuter ou faire exécuter tous les actes de disposition et d'ad-
ministration correspondant à l'objet social de la Société.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou par les Statuts à l'Assemblée Générale sont de la compé-

tence du Conseil ou, le cas échéant, du Gérant Unique.

Art. 16. Délégation de pouvoirs. Le Conseil peut nommer un délégué à la gestion journalière, Associé ou non, membre

du Conseil ou non, qui aura les pleins pouvoirs pour agir au nom de la Société pour tout ce qui concerne la gestion
journalière et les affaires de la Société.

Le Conseil peut nommer une personne, Associé ou non, Gérant ou non, en qualité de représentant permanent de

toute entité dans laquelle la Société est nommée membre du conseil d'administration. Ce représentant permanent agira
de son propre chef, mais au nom et pour le compte de la Société et engagera la Société en sa qualité de membre du
conseil d'administration d'une telle entité.

172050

L

U X E M B O U R G

Le Conseil est aussi autorisé à nommer une personne, Gérant ou non, pour l'exécution de missions spécifiques à tous

les niveaux de la Société.

Art. 17. Signatures autorisées. La Société est engagée en toutes circonstances vis-à-vis des tiers par (i) la signature

conjointe d'au moins un (1) Gérant de catégorie A et au moins un (1) Gérant de catégorie B ou le cas échéant, (ii) la
signature du Gérant Unique.

La Société est également engagée par la signature conjointe de toutes personnes ou l'unique signature de toute per-

sonne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le Conseil ou par le Gérant Unique, et ce dans les
limites des pouvoirs qui leur auront été conférés. Dans les limites de la gestion journalière, la Société sera engagée par
la seule signature, selon le cas, de la personne nommée à cet effet conformément au premier paragraphe de l'article 16
ci-dessus.

Art. 18. Responsabilité du(des) Gérant(s). Le(s) Gérant(s) ne contractent, en raison de leur position, aucune obligation

personnelle concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société dans la mesure où ces enga-
gements  sont  conformes  aux  Statuts  et  à  la  Loi.  Ils  ne  sont  que  des  agents  autorisés  et  ne  sont  donc  simplement
responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 19. Commissaire(s) aux comptes. Si le nombre d'Associés dépasse vingt-cinq (25), les opérations de la Société

seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaire(s) aux comptes ou, dans les cas prévus par la Loi, par un réviseur
d'entreprises agréé.

Les Associés nomment le(s) commissaire(s) aux comptes, s'il y a lieu, et le réviseur d'entreprises agréé, s'il y a lieu, et

déterminent leur nombre, leur rémunération et la durée de leur fonction pour une période ne pouvant excéder six (6)
ans. Le(s) commissaire(s) aux comptes et le réviseur d'entreprises agréé sont rééligibles.

Art. 20. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le premier (1 

er

 ) janvier de chaque année et se

termine le trente et un (31) décembre de chaque année.

Art. 21. Comptes annuels. Chaque année, à la fin de l'année sociale, le Conseil ou, le cas échéant, le Gérant Unique

dressera les comptes annuels de la Société dans la forme requise par la Loi.

Chaque Associé peut inspecter l'état comptable ci-dessus et les comptes annuels au siège social de la Société.

Art. 22. Affectation des bénéfices. Il est prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent (5%) qui sont

affectés à la réserve requise par la loi. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint dix
pour cent (10%) du capital social souscrit de la Société tel qu'il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit
de temps à autre, conformément à l'article 6 ci-dessus, et deviendra à nouveau obligatoire si la réserve légale descend en
dessous de ce seuil d'un dixième (1/10).

L'Assemblée Générale annuelle décide de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel et décide de payer des

dividendes de temps à autre, comme elle estime à sa discrétion convenir au mieux à l'objet et à la politique de la Société
et dans les limites de la Loi.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués, à tout moment, dans les conditions suivantes:
(i) le Conseil ou, le cas échéant, le Gérant Unique, dresse des comptes intérimaires;
(ii) les comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves (en ce compris les primes d'émission)

suffisants sont disponibles pour une distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices
réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant, augmenté
des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit des pertes reportées et des sommes à allouer à la réserve
légale;

(iii) le commissaire aux compte de la Société, le cas échéant, a considéré dans son rapport au Conseil que les conditions

(i) et (ii) ci-dessus ont été satisfaites;

(iv) la décision de distribuer des acomptes sur dividendes doit être prise par les Associés, le Conseil ou, le cas échéant,

le Gérant Unique, dans les deux (2) mois suivant la date des comptes intérimaires;

(v) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société;
(vi) si les acomptes sur dividendes qui ont été distribués dépassent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice

social, les Associés doivent rembourser l'excédent à la Société.

Art. 23. Dissolution. La Société n'est pas dissoute du fait de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité,

de la faillite, de l'insolvabilité ou de tout autre évènement similaire affectant un (1) ou plusieurs Associés.

La Société peut être dissoute, à tout moment, par une résolution de l'Assemblée Générale statuant comme en matière

de modifications des Statuts, dans les conditions prévues à l'article 11 ci-dessus. En cas de dissolution de la Société, il sera
procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou
morales) nommés par l'Assemblée Générale décidant cette liquidation. Cette Assemblée Générale déterminera également
les pouvoirs et la rémunération du ou des liquidateur(s).

Le boni de liquidation, après la réalisation des actifs et le paiement des dettes, sera distribué aux Associés propor-

tionnellement aux Parts Sociales détenues par eux.

172051

L

U X E M B O U R G

Art. 24. Droit applicable. Toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les présents Statuts seront

tranchées conformément à la Loi et, sous réserve des dispositions légales d'ordre public, à tout accord conclu de temps
à autre entre les Associés.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence aujourd'hui et se termine le trente-et-un décembre 2014.

<i>Souscription et libération

Les Statuts ayant ainsi été arrêtés, l'Associé Fondateur, représenté tel que décrit ci-dessus, déclare qu'il souscrit aux

quarante mille (40.000) parts sociales représentant la totalité du capital social souscrit de la Société.

Toutes ces parts sociales ont été entièrement libérées par l'Associé Fondateur par un paiement en numéraire, de sorte

que le montant de quarante mille Dollars des Etats-Unis (USD 40.000,-) payé par l'Associé Fondateur est désormais à la
libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Déclaration - Estimation des frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées aux articles 182 et 183 de la Loi et en

constate expressément l'accomplissement. Il confirme en outre que ces Statuts sont conformes aux dispositions des
articles 27 et 184 de la Loi.

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

en raison du présent acte, sont estimés approximativement à la somme de [devise et montant (en chiffres et en lettres)
- sera complété par le notaire].

<i>Résolutions de l'associé unique

L'Associé  Fondateur,  représenté  tel  que  décrit  ci-dessus,  représentant  l'intégralité  du  capital  social  souscrit  de  la

Société, a pris les résolutions suivantes:

(a) le nombre de gérants est fixé à quatre (4);
(b) les personnes suivantes sont nommées en tant que gérants de la Société ayant un pouvoir de signature A:
- Jaime Cepeda López, économiste, né le 26 janvier 1963, à Bogota, Colombie, ayant son adresse professionnelle à

Street 34 # 6 - 65, Bogota, Colombie; et

- Felipe Zárate Gutierrez, ingénieur civil, né le 7 décembre 1970 à Bogota, Colombie, ayant son adresse professionnelle

à Carrera 43 A # 1 sur 100, Piso 12, Edificio Sudameris, Medellin, Colombie 050010.

et les personnes suivantes sont nommées en tant que gérants de la Société ayant un pouvoir de signature B:
- Xavier Soulard, directeur, né le 14 août 1980, à Chateauroux, France, ayant son adresse professionnelle au 24, rue

Astrid, L-1143 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; et

- Philippe Toussaint, directeur, né le 2 septembre 1975, à Arlon, Belgique, ayant son adresse professionnelle au 10A,

rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

(c) les membres du Conseil sont nommés pour une période indéterminée; et
(d) l'adresse du siège social de la Société est fixé au 24, rue Astrid, L-1143 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte

a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante et en cas de divergence
entre les versions anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, connu du notaire soussigné par son nom, prénom usuel,

état civil et demeure, ledit mandataire de la partie comparante a signé avec le notaire soussigné le présent acte.

Signé: F. Stolz-Page, M. Loesch.
Enregistré à Remich, le 28 octobre 2014. REM/2014/2349. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

Pour expédition conforme.

Mondorf-les-Bains, le 3 novembre 2014.

Référence de publication: 2014171473/662.
(140195787) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2014.

172052

L

U X E M B O U R G

Phoenix III Mixed U, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.000,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 111.631.

Im Jahre zweitausendvierzehn, am neunzehnten September.
Vor Maître Henri HELLINCKX, Notar mit Amtssitz in Luxemburg.

SIND ERSCHIENEN:

die ZBI Invest AG, eine ordnungsgemäß nach deutschem Recht errichtete Aktiengesellschaft mit eingetragenem Sitz

in Henkestrasse 10, D-91054 Erlangen und eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Fürth unter der Nummer
HRB 11315, vertreten durch ihren Vorstand,

und
die Greta 24. Vermögensverwaltungs GmbH, eine ordnungsgemäß nach deutschen Recht errichtete Gesellschaft mit

beschränkter Haftung mit eingetragenem Sitz in Henkestrasse 10, D-91054 Erlangen und eingetragen im Handelsregister
des Amtsgerichts Fürth unter der Nummer HRB 13914, vertreten durch ihre Geschäftsführer,

diese beiden jeweils vertreten durch Claudia PFISTER, Avocat, beruflich ansässig in Luxemburg, per Vollmacht erteilt

am 15. September 2014.

Die vorgenannten Vollmachten werden, nachdem sie „ne varietur” durch den Vertreter der erschienenen Partei und

durch den unterzeichnenden Notar unterschrieben wurden, dieser notariellen Urkunde zum Zweck der Registrierung
beigefügt bleiben.

Die erschienenen Parteien, vertreten wie oben angegeben, haben den unterzeichnenden Notar gebeten, das folgende

festzustellen:

1.) Die ZBI Invest AG und die Greta 24. Vermögensverwaltungs GmbH sind die einzigen Gesellschafter der Phoenix

III  Mixed  U,  einer  Gesellschaft  mit  beschränkter  Haftung  (société  à  responsabilité  limitée),  die  nach  dem  Recht  des
Großherzogtums Luxemburg gegründet wurde, mit eingetragenem Sitz in 35, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, und
eingetragen im luxemburgischen Handels- und Firmenregister unter Nummer B111631, gegründet durch Urkunde des
Notars Jean-Joseph WAGNER, Notar mit Sitz in Sanem, am 8. November 2005, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations (“Mémorial C”) Nr. 302 am 10. Februar 2006, (die “Gesellschaft”). Die Satzung der Gesell-
schaft wurde zuletzt geändert durch Urkunde vom 05. August 2013, veröffentlicht im Mémorial C Nr. 2699 am 29.
Oktober 2013.

2.) Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500), aufgeteilt in fünf-

hundert (500) Anteile (die «Anteile») zu einem Nominalwert von jeweils fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-). Die Greta 24.
Vermögensverwaltungs GmbH hält 470 Anteile an der Gesellschaft und die ZBI Invest AG hält 30 Anteile an der Gesell-
schaft.

3.) Nachdem dies festgestellt wurde, beschlossen die beiden oben genannten Gesellschafter, welche zusammen das

gesamte Gesellschaftskapital der Gesellschaft vertreten (die „Gesellschafter“), eine außerordentliche Hauptversammlung
abzuhalten.

Die Gesellschafter fassten die folgenden Beschlüsse einstimmig:

<i>Erster Beschluss

Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft wird mit sofortiger Wirkung von seinem derzeitigen Betrag von zwölftau-

sendfundhundert Euro (EUR 12.500,-) um zwölftausendfundhundert Euro (EUR 12.500,-) erhöht, so dass es insgesamt
fünfundzwanzigtausend Euro (EUR 25.000,-), aufgeteilt in eintausend (1.000) Anteile zu einem Nominalwert von jeweils
fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-), beträgt.

<i>Zeichnung und Bezahlung

Hierauf erklärte die vorgenannte Greta 24. Vermögensverwaltungs GmbH, vertreten wie oben angegeben, dass sie

nach Bareinzahlung vierhundertsiebzig (470) weitere Anteile der Gesellschaft zu einem Nominalwert von jeweils fün-
fundzwanzig Euro (EUR 25,-), welche vollständig gezahlt sind, zeichnet.

Des Weiteren erklärte die vorgenannte ZBI Invest AG, vertreten wie oben angegeben, dass sie nach Bareinzahlung

dreißig (30) weitere Anteile der Gesellschaft zu einem Nominalwert von jeweils fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) welche
vollständig gezahlt sind, zeichnet.

Die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) steht der Gesellschaft ab sofort zur freien Verfügung,

so wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde.

<i>Zweiter Beschluss

Die Satzung der Gesellschaft wird infolge der oben aufgeführten Beschlüsse geändert, um deren Inhalt in der Satzung

ordnungsgemäß widerzuspiegeln.

172053

L

U X E M B O U R G

Artikel 6 der englischen Fassung der Satzung erhält nunmehr folgenden Wortlaut:

“ Art. 6. The Company's share capital is set at twenty-five thousand euro (EUR 25,000) represented by one thousand

(1,000) shares with a par value of one twenty-five euro (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.”
Artikel 6 der französischen Fassung der Satzung erhält folgenden Wortlaut:

“ Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-) représenté par mille (1.000)

parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.”

<i>Dritter Beschluss

Der eingetragene Sitz der Gesellschaft wird mit Wirkung zum Verlegungstag von 35, avenue Monterey, L-2163 Lu-

xembourg, Großherzogtum Luxemburg, nach Henkestrasse 10, D-91054 Erlangen verlegt.

Durch den Wegzug der Gesellschaft nach Deutschland wird, ohne Aufgabe der Rechtspersönlichkeit der Gesellschaft,

die luxemburgische Nationalität der Gesellschaft in die deutsche Nationalität geändert. Diese Verlegung erfolgt im Einklang
mit Artikel 18 Absatz 2 der Satzung der Gesellschaft und Artikel 199 der aktuellen Fassung des luxemburgischen Gesetzes
vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften durch einstimmigen Beschluss sämtlicher Gesellschafter.

Der Wegzug und die Abänderung der Nationalität wie oben beschrieben sollen an jenem Tag Wirksamkeit erlangen,

an dem die Gesellschaft in das zuständige deutsche Handelsregister eingetragen wird („Verlegungstag“).

Die Gesellschaft und ihre Geschäftsführer werden sämtliche Dokumente einreichen, die notwendig sind, um diesem

Beschluss nach deutschem Recht Wirkung zu verschaffen.

<i>Vierter Beschluss

Die Gesellschaftsform der Gesellschaft wird mit Wirkung zum Verlegungstag von einer luxemburgischen Gesellschaft

mit beschränkter Haftung zu einer deutschen Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt, welche deutschem
Recht und insbesondere dem Gesetz für Gesellschaften mit beschränkter Haftung (“GmbHG”) unterliegt und die folgende
den Bestimmungen des deutschen Rechts und des GmbHG entsprechende vollständig neu gefasste Satzung (die „Neue
Satzung“) hat:

„Gesellschaftsvertrag der Phoenix III Mixed U GmbH

§ 1. Firma und Sitz.
1. Die Firma der Gesellschaft lautet:
Phoenix III Mixed U GmbH
- nachstehend Gesellschaft genannt -
2. Der Sitz der Gesellschaft ist Erlangen.

§ 2. Gegenstand des Unternehmens.
1. Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung und Bewirtschaftung von eigenen Immobilienvermögen.
2. Die Gesellschaft darf alle Maßnahmen treffen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern.

§ 3. Stammkapital, Stammeinlage.
1. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt fünfundzwanzig tausend Euro (EUR 25.000.-)
2. Das Stammkapital ist eingeteilt in eintausend Geschäftsanteile mit den laufenden Nummern von 1 bis 1.000 mit den

jeweils nachstehenden genannten Nennbeträgen. Hierauf übernehmen:

- Greta 24. Vermögensverwaltungs GmbH
neunhundertvierzig (940) Geschäftsanteile im Nennwert von je EUR 25,00 (lfd. Nr. 1 bis 940)
- ZBI Invest AG
sechzig (60) Geschäftsanteile im Nennwert von je EUR 25,00 (lfd. Nr. 941 bis 1.000)
3. Die Geschäftsanteile sind in Geld einzuzahlen.
4. Mehrere voll eingezahlte Geschäftsanteile eines Gesellschafters können durch Gesellschafterbeschluss bei Zustim-

mung des betroffenen Gesellschafters zu einem einheitlichen Geschäftsanteil zusammengelegt werden.

§ 4. Geschäftsführung, Vertretung.
1. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, die von der Gesellschafterversammlung berufen und

abberufen werden. Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so ist er stets alleinvertretungsberechtigt. Sind mehrere Ge-
schäftsführer  vorhanden,  so  wird  die  Gesellschaft  jeweils  von  zwei  Geschäftsführern  gemeinsam  oder  von  einem
Geschäftsführer und einem Prokuristen vertreten. Auch wenn mehrere Geschäftsführer vorhanden sind, kann einem oder
mehreren Geschäftsführern das Recht zur Alleinvertretung verliehen werden.

2. Die Gesellschafterversammlung kann Geschäftsführer von den Beschränkungen des § 181 BGB generell befreien.

172054

L

U X E M B O U R G

3. Haftungsmaßstab für die Geschäftsführung ist die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes.
4. Die Geschäftsführung hat alle Regeln und Beschränkungen des Gesellschaftsvertrages zu beachten. Investitionen in

Immobilien bedürfen eines Gesellschafterbeschlusses gemäß den Regelungen in § 5 dieser Satzung.

5. Die Geschäftsführung ist ermächtigt, der ZBI Zentral Boden Immobilien AG oder einer anderen Gesellschaft der

ZBI Zentral Boden Immobilien-Gruppe, an jedem für Investitionszwecke angeschafften Grundstück, unter Befreiung von
§ 181 BGB, ein unwiderrufliches schuldrechtliches und/oder dingliches Vorkaufsrecht einzuräumen.

6.  Die  Geschäftsleitung  ist  ermächtigt,  freie  Liquidität  mittelbar  oder  unmittelbar  nach  freiem  Ermessen  auf  cash-

Konten, auf Festgeldkonten oder in festverzinslichen Wertpapieren mit einem Rating von mindestens AA (Standard &amp;
Poor's, Moody's oder Fitch Ratings) anzulegen.

§ 5. Investitionsbeschlüsse und Mittelverwendungskontrolle, Kosten.
1. Die Gesellschaft wird nur über solche mittelbaren und unmittelbaren Immobilien Investitionsvorschläge beschließen,

die die ZBI Zentral Boden Immobilien GmbH &amp; Co. Siebte Professional Immobilien Holding KG vorher durch wirksamen
Beschluss der Gesellschafterversammlung oder deren Beirat für kaufenswert befunden hat.

2. Die Freigabe der Investitionsmittel für Immobilieninvestitionen unterliegt der Mittelverwendungskontrolle und rich-

tet sich nach den einschlägigen Vorschriften des Mittelverwendungskontrollvertrages zwischen der ZBI Zentral Boden
Immobilien GmbH &amp; Co. Siebte Professional Immobilien Holding KG und der Treuhand GmbH Franken, dem die Ge-
sellschaft hiermit beitritt.

3. Die Geschäftsführung hat folgende vom Mittelverwendungskontrolleur benötigten Unterlagen vorzubereiten und

zur Verfügung zu stellen:

- Kaufvertrag.
- Grundbuchauszug.
- Gegebenenfalls Altlastengutachten, gegebenenfalls Bodengutachten, gegebenenfalls Holzschutz- und Feuchtigkeitsgu-

tachten.

- Gegebenenfalls Verträge für Dienstbarkeiten.
- Gegebenenfalls Teilungserklärungen oder Unterlagen zur Grundstücksvereinigung.
- Protokoll über eventuell bestehende Baumängel.
- Gegebenenfalls Verwaltervertrag.
- Die Satzung oder den Gesellschaftsvertrag einer zu kaufenden Gesellschaft inklusive aller Nachträge und einen ak-

tuellen Handelsregisterauszug.

- Die Satzung oder den Gesellschaftsvertrag der kaufenden Objektgesellschaft inklusive aller Nachträge und einen

aktuellen Handelsregisterauszug.

- Bei Gewerbeobjekten Mietverträge über mindestens 80,00 % der Mietfläche oder mindestens Kapitaldienst deckend

für die Fremdmittel; bei Wohnobjekten vollständige Mieterlisten und stichprobenweise einzelne Mietverträge.

- Das Grundstück und die Immobilie sind im Erwerbsvorgang lastenfrei zu stellen außer den Belastungen in Abteilung

III, die in Anrechnung auf den Kaufpreis übernommen werden und in Abteilung II, die nicht als wertmindernde Rechte
angesehen werden.

- Technische und kaufmännische Due-Diligence-Prüfung.
- Bei investmentnahen Ausbauten, Umbauten, Sanierungen und Modernisierungen eine schlüssige Gesamtkalkulation

der Geschäftsleitung über die hierfür zu erwartenden Kosten.

4. Die Gesellschaft trägt die Kosten im Sinne von § 12 des Gesellschaftsvertrages der ZBI Zentral Boden Immobilien

GmbH &amp; Co. Siebte Professional Immobilien Holding KG, die mit ihren Immobilieninvestitionen in Zusammenhang stehen,
als eigene Kosten.

§ 6. Gesellschafterbeschlüsse.
1. Die Geschäftsführung hat alljährlich nach Vorliegen des Jahresabschlusses unter Wahrung einer Ladungsfrist von

zwei Wochen, unter Angabe der Tagesordnung und unter Übersendung einer Abschrift des Jahresabschlusses zu einer
ordentlichen Gesellschafterversammlung einzuladen.

2. Beschlüsse der Gesellschafterversammlung sind in allen Angelegenheit der Gesellschaft zulässig. Sie werden, sofern

im Gesellschaftsvertrag oder im Gesetz nichts anderes bestimmt ist, mit einfacher Stimmenmehrheit der Erschienenen
gefasst. Je EUR 25 eines Gesellschaftsanteils gewähren eine Stimme.

3. Die Gesellschafter beschließen insbesondere über:
a) Die von der Geschäftsführung vorzulegenden Immobilienmodernisierungskonzepte.
b) Die durchzuführenden Investitionen gemäß den Vorschlägen der Geschäftsführung auf der Grundlage der vorge-

legten Investitionspläne.

c) Abschluss, Änderung und Beendigung von Dauerschuldverhältnissen, insbesondere Darlehensverträge, Mietverträge,

Pachtverträge und Leasingverträge, soweit dies nicht mit den Investitionen der Gesellschaft und dem dafür benötigten
mittelbaren oder unmittelbaren Fremdkapital in Zusammenhang steht.

172055

L

U X E M B O U R G

d) Die Aufnahme von Fremdwährungsdarlehen, ausgenommen Fremdwährungsdarlehen in Schweizer Franken (CHF),

wenn diese Fremdwährungsdarlehen insgesamt max. 25,00 % aller jeweils am Tage der Unterzeichnung des Darlehens-
vertrages zugesagten konsolidierten Fremdmittel der Gesellschaft und der Objektschwestergesellschaften betragen.

e) Die Feststellung des Jahresabschlusses, die Entnahmen sowie die Entlastung des oder der Geschäftsführer(s) für das

abgelaufene Geschäftsjahr.

f) Die Führung von Aktivprozessen und prozessbeendende Handlungen und Erklärungen ab einem Streitwert von EUR

500.000.

g) Den Verkauf von Immobilien der Gesellschaft, soweit diese mit einem Handelsgewinnaufschlag (nach Abzug der

Courtage für den/die Verkaufsmakler) von weniger als 15,00 % auf den Gestehungspreis gemäß § 5 Absatz 2 des Gesell-
schaftsvertrages der ZBI Zentral Boden Immobilien GmbH &amp; Co. Siebte Professional Immobilien Holding KG veräußert
werden sollen.

h) Änderungen des Gesellschaftsvertrages.
i) Die Umwandlung der Gesellschaft gemäß § 1 UmwG.
j) Eine evtl. Notierung (Listung) an der Börse und/oder Börsengang der Gesellschaft (IPO).
k) Die Annahme von Generalunternehmer-Angeboten oder die Einzelvergabe der Gewerke.
Über Maßnahmen gem. lit. h) bis j) beschließt die Gesellschafterversammlung mit einer Mehrheit von dreiviertel der

abgegebenen Stimmen.

4. Beschließen die Gesellschafter über Investitionen oder über andere Angelegenheiten, die der Mittelverwendungs-

kontrolle unterliegen, so werden sie den § 5 beachten.

5. Gesellschafterbeschlüsse können, vorbehaltlich zwingender gesetzlicher Formvorschriften, wenn alle Gesellschafter

mit diesem Verfahren einverstanden sind, auch fernschriftlich durch Telex oder Telefax oder schriftlich ohne förmliche
Gesellschafterversammlung gefasst werden.

§ 7. Auskunfts- und Einsichtsrechte. Die Gesellschafter haben jederzeit das Recht, die Unterlagen der Gesellschaft

einzusehen.

§ 8. Jahresabschluss.
1. Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind von der Geschäftsführung innerhalb der gesetzlichen Frist

aufzustellen und von den Gesellschaftern festzustellen. Für die Aufstellung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlus-
trechnung gelten die gesetzlichen Bestimmungen und die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung.

2. Die Geschäftsführung hat die Aufstellung des Abschlusses durch einen Wirtschaftsprüfer zu veranlassen mit der

Maßgabe, dass im Rahmen der Aufstellung Prüfungshandlungen vorgenommen und Bericht erstattet wird. Die Gesell-
schafterversammlung kann beschließen, stattdessen den Jahresabschluss einem Wirtschaftsprüfer oder einer Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft zur vollumfänglichen Prüfung vorzulegen.

3. Eine Abschrift des Jahresabschlusses nebst Prüfungsvermerk oder Bescheinigung des Wirtschaftsprüfers oder Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaft ist allen Gesellschaftern zuzuleiten. Dem Mittelverwendungskontrolleur ist der Prüfungsbe-
richt bzw. der ihn ersetzende Bericht über die Aufstellung des Jahresabschlusses zu übermitteln.

§ 9. Geschäftsführervergütung. Die Gesellschaft ist nicht zur Zahlung einer Geschäftsführervergütung verpflichtet. Die

Tätigkeiten des Geschäftsführers werden nicht entgolten.

§ 10. Verteilung des Jahresergebnisses.
1. Über die Verwendung des Jahresergebnisses (Summe aus Jahresüberschuss und Gewinnvortrag abzüglich Verlust-

vortrag) oder - soweit einschlägig - über die Verwendung des Bilanzgewinnes entscheiden die Gesellschafter spätestens
bis zum Ablauf der ersten sechs Monate des Geschäftsjahres mit einfacher Mehrheit.

2. Die Gewinnausschüttung hat binnen einer Frist von 4 Wochen -gerechnet ab Beschlussfassung - zu erfolgen.

§ 11. Dauer der Gesellschaft. Die Gesellschaft ist grundsätzlich auf unbestimmte Zeit errichtet. Sie wird aufgelöst mit

Veräußerung der letzten gehaltenen Immobilie, jedoch nicht vor dem 31. Dezember 2022.

§ 12. Kündigung und Ausscheiden aus der Gesellschaft.
1. Die ordentliche Kündigung des Gesellschaftsvertrages ist ausgeschlossen. Das Recht zur fristlosen Kündigung aus

wichtigem  Grund  bleibt  unberührt.  Durch  die  Kündigung  eines  Gesellschafters  wird  die  Gesellschaft  nicht  aufgelöst,
vielmehr scheidet der kündigende Gesellschafter aus der Gesellschaft aus.

2. Wird ein Gesellschafter zahlungsunfähig, wird über sein Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet oder dessen

Eröffnung mangels Masse abgelehnt, so scheidet der betreffende Gesellschafter mit sofortiger Wirkung aus der Gesell-
schaft - auch wenn diese bereits ihre Auflösung beschlossen hat -aus, ohne dass es eines Gesellschafterbeschlusses oder
einer gerichtlichen Klage bedarf.

3. Wird gegen einen Gesellschafter oder sein Vermögen eine Maßnahme der Zwangsvollstreckung aus einem nicht nur

vorläufig vollstreckbaren Titel in seinen Gesellschaftsanteil eingeleitet, so scheidet der betreffende Gesellschafter nach
Ablauf von vier Wochen, gerechnet vom Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Zwangsvollstreckung an, aus der Gesell-

172056

L

U X E M B O U R G

schaft - auch wenn diese bereits ihre Auflösung beschlossen hat - aus, wenn nicht die Zwangsvollstreckungsmaßnahme
innerhalb dieser Frist aufgehoben wird.

4. Ein Gesellschafter, der Klage auf Auflösung der Gesellschaft erhebt, scheidet mit Rechtshängigkeit der Klage aus der

Gesellschaft aus, die auch in diesem Falle von den verbleibenden Gesellschaftern fortgesetzt wird.

5. Ein Gesellschafter kann aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden, wenn in seiner Person ein wichtiger Grund

gegeben ist. Der ausscheidende Gesellschafter hat bei der Beschlussfassung kein Stimmrecht.

6. Der aufgrund der Kündigung oder durch Ausschluss ausscheidende Gesellschafter erhält eine Abfindung gemäß §

13.

7. Der ausscheidende Gesellschafter ist sodann verpflichtet, nach Wahl der Gesellschaft seinen Anteil (ganz oder

geteilt) an die Gesellschaft selbst, an einen oder mehrere Gesellschafter oder an einen oder mehrere von der Gesellschaft
zu benennende Dritte abzutreten oder die Einziehung seines Anteils zu dulden.

§ 13. Abfindung.
1. Scheidet ein Gesellschafter aus der Gesellschaft aus, erhält er für seine Beteiligung am Gesellschaftsvermögen eine

Abfindung in Geld. Die Abfindung errechnet sich im Falle des Ausscheiden aufgrund der Regelungen in § 12 Absatz 2 - 5
oder aufgrund eines vom ausscheidenden Gesellschafter zu vertretenden Kündigungsgrundes sowie im Falle des Auss-
chlusses wegen nicht vollständig oder nicht gehörig geleisteter Einlage nach Absatz 2, in allen anderen Fällen gemäß Absatz
3.

2. Der Gesellschafter erhält ein Abfindungsguthaben in Höhe des Buchwertes seiner Beteiligung nach dem Stande vom

31.12. des dem Ausscheiden vorangehenden Kalenderjahres, höchstens aber den Betrag der von ihm geleisteten Einlage,
jeweils abzüglich zwischenzeitlicher Entnahmen, zuzüglich des anteiligen Gewinnes und abzüglich eines etwaigen anteiligen
Verlustes.

3. Der Gesellschafter erhält ein Abfindungsguthaben in Höhe des Verkehrswertes seiner Beteiligung. Hierzu werden

die beweglichen Wirtschaftsgüter der Gesellschaft mit einem anhand einschlägiger Listen oder Indizes zu schätzenden
Teilwert angesetzt, der Grundbesitz bei einem Ausscheiden während der Geschäftsjahre 2012 bis einschließlich 2015 mit
dem 12,0-fachen der durchschnittlich für die vorausgegangenen drei Kalenderjahre erzielten Jahresnettomiete (ohne Ne-
benkosten und Mehrwertsteuer), bei einem Ausscheiden während der Geschäftsjahre 2016 ff. mit dem 13,0-fachen der
durchschnittlich für die vorausgegangenen drei Kalenderjahre erzielten Jahresnettomiete (ohne Nebenkosten und Mehr-
wertsteuer) bzw. jeweils maximal mit 20,00 % über dem jeweils ursprünglich bezahlten Einkaufspreis im Sinne des § 5
Absatz 2 UA 4 des Gesellschaftsvertrages der ZBI Zentral Boden Immobilien GmbH &amp; Co. Siebte Professional Immobilien
Holding KG. Die durch das Ausscheiden des Gesellschafters bedingten Kosten und Abgaben sind in Abzug zu bringen.
Ein Geschäftswert wird nicht angesetzt. Das Ergebnis schwebender Geschäfte wird nicht berücksichtigt. Der Abfindungs-
betrag wird von dem für die Gesellschaft tätigen Steuerberater gemäß § 317 BGB auf den Tag des Ausscheidens ermittelt,
wobei, falls zwischen der Gesellschaft und dem ausscheidenden Gesellschafter keine Einstimmigkeit über das Auseinan-
dersetzungsguthaben erzielt werden kann, das Auseinandersetzungsguthaben des ausscheidenden Gesellschafters durch
das Gutachten eines anderen Wirtschaftsprüfers als Schiedsgutachter nach billigem Ermessen festzustellen ist. Die Ent-
scheidung des Schiedsgutachters ist für die Gesellschaft und den ausscheidenden Gesellschafter verbindlich. Können die
Parteien sich nicht auf einen Wirtschaftsprüfer einigen, hat auf den Antrag einer der Parteien die Wirtschaftsprüferkammer
einen Wirtschaftsprüfer zu benennen. Die Kosten des Gutachters tragen die Parteien unter entsprechender Anwendung
des § 91 Absatz 1 ZPO. Über die Kostentragung entscheidet der Schiedsgutachter.

4. Das Abfindungsguthaben ist mit Wirksamwerden des Ausscheidens des Gesellschafters in einem Betrag zur Zahlung

fällig.

5. Sicherheitsleistung für die Zahlung des Abfindungsguthabens kann der ausscheidende Gesellschafter nicht verlangen.

§ 14. Liquidation.
1. Die Liquidation erfolgt durch den oder die Geschäftsführer.
2. Über eine Liquidationsvergütung beschließt die Gesellschafterversammlung.
3. Das nach Befriedigung der Gläubiger verbleibende Vermögen der Gesellschaft wird nach dem Verhältnis der Ge-

schäftsanteile verteilt.

§ 15. Erfüllungsort. Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle sich aus diesem Vertrag oder aufgrund dieses Vertrages

ergebenden Ansprüche ist - soweit gesetzlich zulässig - Erlangen.

§ 16. Wettbewerbsverbot. Die Geschäftsführer und die Gesellschafter sind vom Wettbewerbsverbot befreit. Sofern

ein Geschäftsführer einem Wettbewerbsverbot unterliegen soll, wird dieses im jeweiligen Anstellungsvertrag geregelt.

§ 17. Schlussbestimmungen.
1. Nebenabreden. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages sowie alle das Gesellschaftsverhältnis betreffenden

Vereinbarungen der Gesellschafter untereinander und mit der Gesellschaft bedürfen der Schriftform, soweit nicht kraft
zwingenden Gesetzes eine strengere Form vorgeschrieben ist. Auf das Schriftformerfordernis kann nur schriftlich ver-
zichtet werden.

172057

L

U X E M B O U R G

2. Sollten Bestimmungen dieses Vertrages oder eine künftig in ihm aufgenommene Bestimmung ganz oder teilweise

nicht rechtswirksam oder nicht durchführbar sein oder ihre Rechtswirksamkeit oder Durchführbarkeit später verlieren,
so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen des Vertrages nicht berührt. Das gleiche gilt, soweit sich
herausstellen sollte, dass der Vertrag eine Regelungslücke enthält. Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren
Bestimmungen oder zur Ausfüllung der Lücke soll eine angemessene Regelung gelten, die, soweit rechtlich möglich, dem
am nächsten kommt, was die Gesellschafter gewollt haben oder nach dem Sinn und Zweck des Vertrages gewollt haben
würden, sofern sie bei Abschluss dieses Vertrages oder bei der späteren Aufnahme einer Bestimmung den Punkt bedacht
hätten.

3. Die Kosten dieses Vertrages und der notwendigen Registereintragungen (Gründungskosten) trägt die Gesellschaft

bis zu einem Betrag von EUR 1.700.

4. Alle Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im elektronischen Bundesanzeiger.“

<i>Fünfter Beschluss

Die Gesellschafter akzeptieren den Rücktritt des alleinigen Geschäftsführers Herrn Matthias SPRENKER, beruflich

ansässig in 35, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, mit Wirkung um Mitternacht des Kalendertages vor dem Verle-
gungstag.

Dem bis zum Verlegungstag amtierenden bisherigen Geschäftsführer wird für den Zeitraum, der am Kalendertag vor

dem Verlegungstag endet, Entlastung von seiner Haftung gegenüber der Gesellschaft bezüglich der von ihm ausgeführten
Tätigkeit als Geschäftsführer erteilt.

Zum Verlegungstag übergibt der ausscheidende luxemburgische Geschäftsführer die Geschäftsführung an die unten

benannten neuen Geschäftsführer in Deutschland.

Die Gesellschafter ernennen mit Wirkung ab dem Verlegungstag die folgenden Personen als Geschäftsführer:
a) Herr Dr. Bernd Konrad ITAL, geboren am 03.03.1965 in Mönchengladbach, Deutschland, geschäftsansässig in der

Henkestrasse 10, D-91054 Erlangen; und

b) Herr Felix Sebastian BADER, geboren am 16.06.1981 in Erlangen, Deutschland, geschäftsansässig in der Henkestrasse

10, D-91054 Erlangen.

<i>Sechster Beschluss

Die Gesellschafter bestätigen:
(i) Die Neue Satzung steht im Einklang mit dem Recht der Bundesrepublik Deutschland;
(ii) Die Gesellschaft wird mit Wirkung um Mitternacht des Kalendertages vor dem Verlegungstag aufhören, als lu-

xemburgische  Gesellschaft  zu  existieren,  und  ab  dem  Verlegungstag  dem  anwendbaren  Recht  der  Bundesrepublik
Deutschland unterliegen;

(iii) Die Verlegung des eingetragenen Sitzes der Gesellschaft, die Änderung der Sitzlandes und der Nationalität der

Gesellschaft sowie die Änderung der Gesellschaftsform führen weder zu einer Auflösung und / oder Liquidation der
Gesellschaft noch zur Schaffung einer neuen juristischen Person und erfolgen im Einklang mit allen anwendbaren deutschen
Vorschriften.

<i>Siebenter Beschluss

Dem derzeitigen luxemburgischen Geschäftsführer, dem Rechtsanwalt Marcus PETER mit Sitz in Luxemburg und dem

Wirtschaftsprüfer Wolfgang BLAUBERGER mit Sitz in München wird jeweils einzeln unbeschränkte Vollmacht erteilt
einschließlich des Rechts, Untervollmacht zu erteilen, um die oben genannten Beschlüsse auszuführen und wirksam wer-
den  zu  lassen.  Dazu  gehören  insbesondere  die  Einreichung  von  Unterlagen  beim  deutschen  und  luxemburgischen
Handelsregister.

<i>Achter Beschluss

Die Bücher und Unterlagen, die am bisherigen Sitz der Gesellschaft in Luxemburg verwahrt wurden, werden so bald

wie möglich nach dem Verlegungstag an den oben genannten neuen Sitz der Gesellschaft in Deutschland transferiert.

<i>Bestätigung des Notars über die Kapitalerhöhung

Die gemäß dem ersten Beschluss erfolgte Kapitalerhöhung wird am Tag dieser außerordentlichen Hauptversammlung

wirksam.

Der unterzeichnende Notar bestätigt daher, dass das Kapital der Gesellschaft am Tag dieser notariellen Urkunde

fünfundzwanzigtausend Euro (EUR 25.000,-), aufgeteilt in eintausend (1.000) Anteile zu einem Nominalwert von jeweils
fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-), beträgt.

<i>Kosten

Die aufgrund dieser Versammlung angefallenen Ausgaben, Kosten, Entschädigungen oder Gebühren jeglicher Form,

welche durch die Gesellschaft zu begleichen sind, werden auf ungefähr EUR 2.500,- geschätzt.

Worüber Urkunde aufgenommen wurde in Luxemburg, an dem zu Anfang dieser Urkunde erwähnten Datum.

172058

L

U X E M B O U R G

Nachdem diese Urkunde der anwesenden Person, welche dem unterzeichneten Notar durch Name, Nachname, Fa-

milienstand und Anschrift bekannt ist, vorgelesen wurde, hat die anwesende Person zusammen mit dem Notar diese
Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: C. PFISTER und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 septembre 2014. Relation: LAC/2014/45103. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur

 (signé): I. THILL.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG – der Gesellschaft auf Begehr erteilt.

Luxemburg, den 4. November 2014.

Référence de publication: 2014171462/341.
(140195441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2014.

Phoenix III Mixed R, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.000,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 111.628.

Im Jahre zweitausendvierzehn, am neunzehnten September.
Vor Maître Henri HELLINCKX, Notar mit Amtssitz in Luxemburg.

SIND ERSCHIENEN:

die ZBI Invest AG, eine ordnungsgemäß nach deutschem Recht errichtete Aktiengesellschaft mit eingetragenem Sitz

in Henkestrasse 10, D-91054 Erlangen und eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Fürth unter der Nummer
HRB 11315, vertreten durch ihren Vorstand,

und
die Greta 24. Vermögensverwaltungs GmbH, eine ordnungsgemäß nach deutschen Recht errichtete Gesellschaft mit

beschränkter Haftung mit eingetragenem Sitz in Henkestrasse 10, D-91054 Erlangen und eingetragen im Handelsregister
des Amtsgerichts Fürth unter der Nummer HRB 13914, vertreten durch ihre Geschäftsführer,

diese beiden jeweils vertreten durch Claudia PFISTER, Avocat, beruflich ansässig in Luxemburg, per Vollmacht erteilt

am 15. September 2014.

Die vorgenannten Vollmachten werden, nachdem sie „ne varietur” durch den Vertreter der erschienenen Partei und

durch den unterzeichnenden Notar unterschrieben wurden, dieser notariellen Urkunde zum Zweck der Registrierung
beigefügt bleiben.

Die erschienenen Parteien, vertreten wie oben angegeben, haben den unterzeichnenden Notar gebeten, das folgende

festzustellen:

1.) Die ZBI Invest AG und die Greta 24. Vermögensverwaltungs GmbH sind die einzigen Gesellschafter der Phoenix

III  Mixed  R,  einer  Gesellschaft  mit  beschränkter  Haftung  (société  à  responsabilité  limitée),  die  nach  dem  Recht  des
Großherzogtums Luxemburg gegründet wurde, mit eingetragenem Sitz in 35, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, und
eingetragen im luxemburgischen Handels- und Firmenregister unter Nummer B111628, gegründet durch Urkunde des
Notars Jean-Joseph WAGNER, Notar mit Sitz in Sanem, am 8. November 2005, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations (“Mémorial C”) Nr. 337 am 15. Februar 2006, (die “Gesellschaft”). Die Satzung der Gesell-
schaft wurde zuletzt geändert durch Urkunde vom 05. August 2013, veröffentlicht im Mémorial C Nr. 2737 am 02.
November 2013.

2.) Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500), aufgeteilt in fünf-

hundert (500) Anteile (die «Anteile») zu einem Nominalwert von jeweils fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-). Die Greta 24.
Vermögensverwaltungs GmbH hält 470 Anteile an der Gesellschaft und die ZBI Invest AG hält 30 Anteile an der Gesell-
schaft.

3.) Nachdem dies festgestellt wurde, beschlossen die beiden oben genannten Gesellschafter, welche zusammen das

gesamte Gesellschaftskapital der Gesellschaft vertreten (die „Gesellschafter“), eine außerordentliche Hauptversammlung
abzuhalten.

Die Gesellschafter fassten die folgenden Beschlüsse einstimmig:

<i>Erster Beschluss

Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft wird mit sofortiger Wirkung von seinem derzeitigen Betrag von zwölftau-

sendfundhundert Euro (EUR 12.500,-) um zwölftausendfundhundert Euro (EUR 12.500,-) erhöht, so dass es insgesamt
fünfundzwanzigtausend Euro (EUR 25.000,-), aufgeteilt in eintausend (1.000) Anteile zu einem Nominalwert von jeweils
fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-), beträgt.

172059

L

U X E M B O U R G

<i>Zeichnung und Bezahlung

Hierauf erklärte die vorgenannte Greta 24. Vermögensverwaltungs GmbH, vertreten wie oben angegeben, dass sie

nach Bareinzahlung vierhundertsiebzig (470) weitere Anteile der Gesellschaft zu einem Nominalwert von jeweils fün-
fundzwanzig Euro (EUR 25,-), welche vollständig gezahlt sind, zeichnet.

Des Weiteren erklärte die vorgenannte ZBI Invest AG, vertreten wie oben angegeben, dass sie nach Bareinzahlung

dreißig (30) weitere Anteile der Gesellschaft zu einem Nominalwert von jeweils fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) welche
vollständig gezahlt sind, zeichnet.

Die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) steht der Gesellschaft ab sofort zur freien Verfügung,

so wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde.

<i>Zweiter Beschluss

Die Satzung der Gesellschaft wird infolge der oben aufgeführten Beschlüsse geändert, um deren Inhalt in der Satzung

ordnungsgemäß widerzuspiegeln.

Artikel 6 der englischen Fassung der Satzung erhält nunmehr folgenden Wortlaut:

“ Art. 6. The Company's share capital is set at twenty-five thousand euro (EUR 25,000) represented by one thousand

(1,000) shares with a par value of one twenty-five euro (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.”
Artikel 6 der französischen Fassung der Satzung erhält folgenden Wortlaut:

“ Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-) représenté par mille (1.000)

parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.”

<i>Dritter Beschluss

Der eingetragene Sitz der Gesellschaft wird mit Wirkung zum Verlegungstag von 35, avenue Monterey, L-2163 Lu-

xembourg, Großherzogtum Luxemburg, nach Henkestrasse 10, D-91054 Erlangen verlegt.

Durch den Wegzug der Gesellschaft nach Deutschland wird, ohne Aufgabe der Rechtspersönlichkeit der Gesellschaft,

die luxemburgische Nationalität der Gesellschaft in die deutsche Nationalität geändert. Diese Verlegung erfolgt im Einklang
mit Artikel 18 Absatz 2 der Satzung der Gesellschaft und Artikel 199 der aktuellen Fassung des luxemburgischen Gesetzes
vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften durch einstimmigen Beschluss sämtlicher Gesellschafter.

Der Wegzug und die Abänderung der Nationalität wie oben beschrieben sollen an jenem Tag Wirksamkeit erlangen,

an dem die Gesellschaft in das zuständige deutsche Handelsregister eingetragen wird („Verlegungstag“).

Die Gesellschaft und ihre Geschäftsführer werden sämtliche Dokumente einreichen, die notwendig sind, um diesem

Beschluss nach deutschem Recht Wirkung zu verschaffen.

<i>Vierter Beschluss

Die Gesellschaftsform der Gesellschaft wird mit Wirkung zum Verlegungstag von einer luxemburgischen Gesellschaft

mit beschränkter Haftung zu einer deutschen Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt, welche deutschem
Recht und insbesondere dem Gesetz für Gesellschaften mit beschränkter Haftung (“GmbHG”) unterliegt und die folgende
den Bestimmungen des deutschen Rechts und des GmbHG entsprechende vollständig neu gefasste Satzung (die „Neue
Satzung“) hat:

„Gesellschaftsvertrag der Phoenix III Mixed R GmbH

§ 1. Firma und Sitz.
1. Die Firma der Gesellschaft lautet:
Phoenix III Mixed R GmbH
- nachstehend Gesellschaft genannt -
2. Der Sitz der Gesellschaft ist Erlangen.

§ 2. Gegenstand des Unternehmens.
1. Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung und Bewirtschaftung von eigenen Immobilienvermögen.
2. Die Gesellschaft darf alle Maßnahmen treffen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern.

§ 3. Stammkapital, Stammeinlage.
1. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt fünfundzwanzig tausend Euro (EUR 25.000,-).
2. Das Stammkapital ist eingeteilt in eintausend Geschäftsanteile mit den laufenden Nummern von 1 bis 1.000 mit den

jeweils nachstehenden genannten Nennbeträgen. Hierauf übernehmen:

- Greta 24. Vermögensverwaltungs GmbH

172060

L

U X E M B O U R G

neunhundertvierzig (940) Geschäftsanteile im Nennwert von je EUR 25,00 (lfd. Nr. 1 bis 940)
- ZBI Invest AG
sechzig (60) Geschäftsanteile im Nennwert von je EUR 25,00 (lfd. Nr. 941 bis 1.000)
3. Die Geschäftsanteile sind in Geld einzuzahlen.
4. Mehrere voll eingezahlte Geschäftsanteile eines Gesellschafters können durch Gesellschafterbeschluss bei Zustim-

mung des betroffenen Gesellschafters zu einem einheitlichen Geschäftsanteil zusammengelegt werden.

§ 4. Geschäftsführung, Vertretung.
1. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, die von der Gesellschafterversammlung berufen und

abberufen werden. Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so ist er stets alleinvertretungsberechtigt. Sind mehrere Ge-
schäftsführer  vorhanden,  so  wird  die  Gesellschaft  jeweils  von  zwei  Geschäftsführern  gemeinsam  oder  von  einem
Geschäftsführer und einem Prokuristen vertreten. Auch wenn mehrere Geschäftsführer vorhanden sind, kann einem oder
mehreren Geschäftsführern das Recht zur Alleinvertretung verliehen werden.

2. Die Gesellschafterversammlung kann Geschäftsführer von den Beschränkungen des § 181 BGB generell befreien.
3. Haftungsmaßstab für die Geschäftsführung ist die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes.
4. Die Geschäftsführung hat alle Regeln und Beschränkungen des Gesellschaftsvertrages zu beachten. Investitionen in

Immobilien bedürfen eines Gesellschafterbeschlusses gemäß den Regelungen in § 5 dieser Satzung.

5. Die Geschäftsführung ist ermächtigt, der ZBI Zentral Boden Immobilien AG oder einer anderen Gesellschaft der

ZBI Zentral Boden Immobilien-Gruppe, an jedem für Investitionszwecke angeschafften Grundstück, unter Befreiung von
§ 181 BGB, ein unwiderrufliches schuldrechtliches und/oder dingliches Vorkaufsrecht einzuräumen.

6.  Die  Geschäftsleitung  ist  ermächtigt,  freie  Liquidität  mittelbar  oder  unmittelbar  nach  freiem  Ermessen  auf  cash-

Konten, auf Festgeldkonten oder in festverzinslichen Wertpapieren mit einem Rating von mindestens AA (Standard &amp;
Poor's, Moody's oder Fitch Ratings) anzulegen.

§ 5. Investitionsbeschlüsse und Mittelverwendungskontrolle, Kosten.
1. Die Gesellschaft wird nur über solche mittelbaren und unmittelbaren Immobilien Investitionsvorschläge beschließen,

die die ZBI Zentral Boden Immobilien GmbH &amp; Co. Siebte Professional Immobilien Holding KG vorher durch wirksamen
Beschluss der Gesellschafterversammlung oder deren Beirat für kaufenswert befunden hat.

2. Die Freigabe der Investitionsmittel für Immobilieninvestitionen unterliegt der Mittelverwendungskontrolle und rich-

tet sich nach den einschlägigen Vorschriften des Mittelverwendungskontrollvertrages zwischen der ZBI Zentral Boden
Immobilien GmbH &amp; Co. Siebte Professional Immobilien Holding KG und der Treuhand GmbH Franken, dem die Ge-
sellschaft hiermit beitritt.

3. Die Geschäftsführung hat folgende vom Mittelverwendungskontrolleur benötigten Unterlagen vorzubereiten und

zur Verfügung zu stellen:

- Kaufvertrag.
- Grundbuchauszug.
- Gegebenenfalls Altlastengutachten, gegebenenfalls Bodengutachten, gegebenenfalls Holzschutz- und Feuchtigkeitsgu-

tachten.

- Gegebenenfalls Verträge für Dienstbarkeiten.
- Gegebenenfalls Teilungserklärungen oder Unterlagen zur Grundstücksvereinigung.
- Protokoll über eventuell bestehende Baumängel.
- Gegebenenfalls Verwaltervertrag.
- Die Satzung oder den Gesellschaftsvertrag einer zu kaufenden Gesellschaft inklusive aller Nachträge und einen ak-

tuellen Handelsregisterauszug.

- Die Satzung oder den Gesellschaftsvertrag der kaufenden Objektgesellschaft inklusive aller Nachträge und einen

aktuellen Handelsregisterauszug.

- Bei Gewerbeobjekten Mietverträge über mindestens 80,00 % der Mietfläche oder mindestens Kapitaldienst deckend

für die Fremdmittel; bei Wohnobjekten vollständige Mieterlisten und stichprobenweise einzelne Mietverträge.

- Das Grundstück und die Immobilie sind im Erwerbsvorgang lastenfrei zu stellen außer den Belastungen in Abteilung

III, die in Anrechnung auf den Kaufpreis übernommen werden und in Abteilung II, die nicht als wertmindernde Rechte
angesehen werden.

- Technische und kaufmännische Due-Diligence-Prüfung.
- Bei investmentnahen Ausbauten, Umbauten, Sanierungen und Modernisierungen eine schlüssige Gesamtkalkulation

der Geschäftsleitung über die hierfür zu erwartenden Kosten.

4. Die Gesellschaft trägt die Kosten im Sinne von § 12 des Gesellschaftsvertrages der ZBI Zentral Boden Immobilien

GmbH &amp; Co. Siebte Professional Immobilien Holding KG, die mit ihren Immobilieninvestitionen in Zusammenhang stehen,
als eigene Kosten.

172061

L

U X E M B O U R G

§ 6. Gesellschafterbeschlüsse.
1. Die Geschäftsführung hat alljährlich nach Vorliegen des Jahresabschlusses unter Wahrung einer Ladungsfrist von

zwei Wochen, unter Angabe der Tagesordnung und unter Übersendung einer Abschrift des Jahresabschlusses zu einer
ordentlichen Gesellschafterversammlung einzuladen.

2. Beschlüsse der Gesellschafterversammlung sind in allen Angelegenheit der Gesellschaft zulässig. Sie werden, sofern

im Gesellschaftsvertrag oder im Gesetz nichts anderes bestimmt ist, mit einfacher Stimmenmehrheit der Erschienenen
gefasst. Je EUR 25 eines Gesellschaftsanteils gewähren eine Stimme.

3. Die Gesellschafter beschließen insbesondere über:
a) Die von der Geschäftsführung vorzulegenden Immobilienmodernisierungskonzepte.
b) Die durchzuführenden Investitionen gemäß den Vorschlägen der Geschäftsführung auf der Grundlage der vorge-

legten Investitionspläne.

c) Abschluss, Änderung und Beendigung von Dauerschuldverhältnissen, insbesondere Darlehensverträge, Mietverträge,

Pachtverträge und Leasingverträge, soweit dies nicht mit den Investitionen der Gesellschaft und dem dafür benötigten
mittelbaren oder unmittelbaren Fremdkapital in Zusammenhang steht.

d) Die Aufnahme von Fremdwährungsdarlehen, ausgenommen Fremdwährungsdarlehen in Schweizer Franken (CHF),

wenn diese Fremdwährungsdarlehen insgesamt max. 25,00 % aller jeweils am Tage der Unterzeichnung des Darlehens-
vertrages zugesagten konsolidierten Fremdmittel der Gesellschaft und der Objektschwestergesellschaften betragen.

e) Die Feststellung des Jahresabschlusses, die Entnahmen sowie die Entlastung des oder der Geschäftsführer(s) für das

abgelaufene Geschäftsjahr.

f) Die Führung von Aktivprozessen und prozessbeendende Handlungen und Erklärungen ab einem Streitwert von EUR

500.000.

g) Den Verkauf von Immobilien der Gesellschaft, soweit diese mit einem Handelsgewinnaufschlag (nach Abzug der

Courtage für den/die Verkaufsmakler) von weniger als 15,00 % auf den Gestehungspreis gemäß § 5 Absatz 2 des Gesell-
schaftsvertrages der ZBI Zentral Boden Immobilien GmbH &amp; Co. Siebte Professional Immobilien Holding KG veräußert
werden sollen.

h) Änderungen des Gesellschaftsvertrages.
i) Die Umwandlung der Gesellschaft gemäß § 1 UmwG.
j) Eine evtl. Notierung (Listung) an der Börse und/oder Börsengang der Gesellschaft (IPO).
k) Die Annahme von Generalunternehmer-Angeboten oder die Einzelvergabe der Gewerke.
Über Maßnahmen gem. lit. h) bis j) beschließt die Gesellschafterversammlung mit einer Mehrheit von dreiviertel der

abgegebenen Stimmen.

4. Beschließen die Gesellschafter über Investitionen oder über andere Angelegenheiten, die der Mittelverwendungs-

kontrolle unterliegen, so werden sie den § 5 beachten.

5. Gesellschafterbeschlüsse können, vorbehaltlich zwingender gesetzlicher Formvorschriften, wenn alle Gesellschafter

mit diesem Verfahren einverstanden sind, auch fernschriftlich durch Telex oder Telefax oder schriftlich ohne förmliche
Gesellschafterversammlung gefasst werden.

§ 7. Auskunfts - und Einsichtsrechte. Die Gesellschafter haben jederzeit das Recht, die Unterlagen der Gesellschaft

einzusehen.

§ 8. Jahresabschluss.
1. Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind von der Geschäftsführung innerhalb der gesetzlichen Frist

aufzustellen und von den Gesellschaftern festzustellen. Für die Aufstellung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlus-
trechnung gelten die gesetzlichen Bestimmungen und die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung.

2. Die Geschäftsführung hat die Aufstellung des Abschlusses durch einen Wirtschaftsprüfer zu veranlassen mit der

Maßgabe, dass im Rahmen der Aufstellung Prüfungshandlungen vorgenommen und Bericht erstattet wird. Die Gesell-
schafterversammlung kann beschließen, stattdessen den Jahresabschluss einem Wirtschaftsprüfer oder einer Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft zur vollumfänglichen Prüfung vorzulegen.

3. Eine Abschrift des Jahresabschlusses nebst Prüfungsvermerk oder Bescheinigung des Wirtschaftsprüfers oder Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaft ist allen Gesellschaftern zuzuleiten. Dem Mittelverwendungskontrolleur ist der Prüfungsbe-
richt bzw. der ihn ersetzende Bericht über die Aufstellung des Jahresabschlusses zu übermitteln.

§ 9. Geschäftsführervergütung. Die Gesellschaft ist nicht zur Zahlung einer Geschäftsführervergütung verpflichtet. Die

Tätigkeiten des Geschäftsführers werden nicht entgolten.

§ 10. Verteilung des Jahresergebnisses.
1. Über die Verwendung des Jahresergebnisses (Summe aus Jahresüberschuss und Gewinnvortrag abzüglich Verlust-

vortrag) oder - soweit einschlägig - über die Verwendung des Bilanzgewinnes entscheiden die Gesellschafter spätestens
bis zum Ablauf der ersten sechs Monate des Geschäftsjahres mit einfacher Mehrheit.

2. Die Gewinnausschüttung hat binnen einer Frist von 4 Wochen -gerechnet ab Beschlussfassung - zu erfolgen.

172062

L

U X E M B O U R G

§ 11. Dauer der Gesellschaft. Die Gesellschaft ist grundsätzlich auf unbestimmte Zeit errichtet. Sie wird aufgelöst mit

Veräußerung der letzten gehaltenen Immobilie, jedoch nicht vor dem 31. Dezember 2022.

§ 12. Kündigung und Ausscheiden aus der Gesellschaft.
1. Die ordentliche Kündigung des Gesellschaftsvertrages ist ausgeschlossen. Das Recht zur fristlosen Kündigung aus

wichtigem  Grund  bleibt  unberührt.  Durch  die  Kündigung  eines  Gesellschafters  wird  die  Gesellschaft  nicht  aufgelöst,
vielmehr scheidet der kündigende Gesellschafter aus der Gesellschaft aus.

2. Wird ein Gesellschafter zahlungsunfähig, wird über sein Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet oder dessen

Eröffnung mangels Masse abgelehnt, so scheidet der betreffende Gesellschafter mit sofortiger Wirkung aus der Gesell-
schaft - auch wenn diese bereits ihre Auflösung beschlossen hat -aus, ohne dass es eines Gesellschafterbeschlusses oder
einer gerichtlichen Klage bedarf.

3. Wird gegen einen Gesellschafter oder sein Vermögen eine Maßnahme der Zwangsvollstreckung aus einem nicht nur

vorläufig vollstreckbaren Titel in seinen Gesellschaftsanteil eingeleitet, so scheidet der betreffende Gesellschafter nach
Ablauf von vier Wochen, gerechnet vom Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Zwangsvollstreckung an, aus der Gesell-
schaft - auch wenn diese bereits ihre Auflösung beschlossen hat - aus, wenn nicht die Zwangsvollstreckungsmaßnahme
innerhalb dieser Frist aufgehoben wird.

4. Ein Gesellschafter, der Klage auf Auflösung der Gesellschaft erhebt, scheidet mit Rechtshängigkeit der Klage aus der

Gesellschaft aus, die auch in diesem Falle von den verbleibenden Gesellschaftern fortgesetzt wird.

5. Ein Gesellschafter kann aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden, wenn in seiner Person ein wichtiger Grund

gegeben ist. Der ausscheidende Gesellschafter hat bei der Beschlussfassung kein Stimmrecht.

6. Der aufgrund der Kündigung oder durch Ausschluss ausscheidende Gesellschafter erhält eine Abfindung gemäß §

13.

7. Der ausscheidende Gesellschafter ist sodann verpflichtet, nach Wahl der Gesellschaft seinen Anteil (ganz oder

geteilt) an die Gesellschaft selbst, an einen oder mehrere Gesellschafter oder an einen oder mehrere von der Gesellschaft
zu benennende Dritte abzutreten oder die Einziehung seines Anteils zu dulden.

§ 13. Abfindung.
1. Scheidet ein Gesellschafter aus der Gesellschaft aus, erhält er für seine Beteiligung am Gesellschaftsvermögen eine

Abfindung in Geld. Die Abfindung errechnet sich im Falle des Ausscheiden aufgrund der Regelungen in § 12 Absatz 2 - 5
oder aufgrund eines vom ausscheidenden Gesellschafter zu vertretenden Kündigungsgrundes sowie im Falle des Auss-
chlusses wegen nicht vollständig oder nicht gehörig geleisteter Einlage nach Absatz 2, in allen anderen Fällen gemäß Absatz
3.

2. Der Gesellschafter erhält ein Abfindungsguthaben in Höhe des Buchwertes seiner Beteiligung nach dem Stande vom

31.12. des dem Ausscheiden vorangehenden Kalenderjahres, höchstens aber den Betrag der von ihm geleisteten Einlage,
jeweils abzüglich zwischenzeitlicher Entnahmen, zuzüglich des anteiligen Gewinnes und abzüglich eines etwaigen anteiligen
Verlustes.

3. Der Gesellschafter erhält ein Abfindungsguthaben in Höhe des Verkehrswertes seiner Beteiligung. Hierzu werden

die beweglichen Wirtschaftsgüter der Gesellschaft mit einem anhand einschlägiger Listen oder Indizes zu schätzenden
Teilwert angesetzt, der Grundbesitz bei einem Ausscheiden während der Geschäftsjahre 2012 bis einschließlich 2015 mit
dem 12,0-fachen der durchschnittlich für die vorausgegangenen drei Kalenderjahre erzielten Jahresnettomiete (ohne Ne-
benkosten und Mehrwertsteuer), bei einem Ausscheiden während der Geschäftsjahre 2016 ff. mit dem 13,0-fachen der
durchschnittlich für die vorausgegangenen drei Kalenderjahre erzielten Jahresnettomiete (ohne Nebenkosten und Mehr-
wertsteuer) bzw. jeweils maximal mit 20,00 % über dem jeweils ursprünglich bezahlten Einkaufspreis im Sinne des § 5
Absatz 2 UA 4 des Gesellschaftsvertrages der ZBI Zentral Boden Immobilien GmbH &amp; Co. Siebte Professional Immobilien
Holding KG. Die durch das Ausscheiden des Gesellschafters bedingten Kosten und Abgaben sind in Abzug zu bringen.
Ein Geschäftswert wird nicht angesetzt. Das Ergebnis schwebender Geschäfte wird nicht berücksichtigt. Der Abfindungs-
betrag wird von dem für die Gesellschaft tätigen Steuerberater gemäß § 317 BGB auf den Tag des Ausscheidens ermittelt,
wobei, falls zwischen der Gesellschaft und dem ausscheidenden Gesellschafter keine Einstimmigkeit über das Auseinan-
dersetzungsguthaben erzielt werden kann, das Auseinandersetzungsguthaben des ausscheidenden Gesellschafters durch
das Gutachten eines anderen Wirtschaftsprüfers als Schiedsgutachter nach billigem Ermessen festzustellen ist. Die Ent-
scheidung des Schiedsgutachters ist für die Gesellschaft und den ausscheidenden Gesellschafter verbindlich. Können die
Parteien sich nicht auf einen Wirtschaftsprüfer einigen, hat auf den Antrag einer der Parteien die Wirtschaftsprüferkammer
einen Wirtschaftsprüfer zu benennen. Die Kosten des Gutachters tragen die Parteien unter entsprechender Anwendung
des § 91 Absatz 1 ZPO. Über die Kostentragung entscheidet der Schiedsgutachter.

4. Das Abfindungsguthaben ist mit Wirksamwerden des Ausscheidens des Gesellschafters in einem Betrag zur Zahlung

fällig.

5. Sicherheitsleistung für die Zahlung des Abfindungsguthabens kann der ausscheidende Gesellschafter nicht verlangen.

§ 14. Liquidation.
1. Die Liquidation erfolgt durch den oder die Geschäftsführer.
2. Über eine Liquidationsvergütung beschließt die Gesellschafterversammlung.

172063

L

U X E M B O U R G

3. Das nach Befriedigung der Gläubiger verbleibende Vermögen der Gesellschaft wird nach dem Verhältnis der Ge-

schäftsanteile verteilt.

§ 15. Erfüllungsort. Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle sich aus diesem Vertrag oder aufgrund dieses Vertrages

ergebenden Ansprüche ist - soweit gesetzlich zulässig - Erlangen.

§ 16. Wettbewerbsverbot. Die Geschäftsführer und die Gesellschafter sind vom Wettbewerbsverbot befreit. Sofern

ein Geschäftsführer einem Wettbewerbsverbot unterliegen soll, wird dieses im jeweiligen Anstellungsvertrag geregelt.

§ 17. Schlussbestimmungen.
1. Nebenabreden. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages sowie alle das Gesellschaftsverhältnis betreffenden

Vereinbarungen der Gesellschafter untereinander und mit der Gesellschaft bedürfen der Schriftform, soweit nicht kraft
zwingenden Gesetzes eine strengere Form vorgeschrieben ist. Auf das Schriftformerfordernis kann nur schriftlich ver-
zichtet werden.

2. Sollten Bestimmungen dieses Vertrages oder eine künftig in ihm aufgenommene Bestimmung ganz oder teilweise

nicht rechtswirksam oder nicht durchführbar sein oder ihre Rechtswirksamkeit oder Durchführbarkeit später verlieren,
so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen des Vertrages nicht berührt. Das gleiche gilt, soweit sich
herausstellen sollte, dass der Vertrag eine Regelungslücke enthält. Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren
Bestimmungen oder zur Ausfüllung der Lücke soll eine angemessene Regelung gelten, die, soweit rechtlich möglich, dem
am nächsten kommt, was die Gesellschafter gewollt haben oder nach dem Sinn und Zweck des Vertrages gewollt haben
würden, sofern sie bei Abschluss dieses Vertrages oder bei der späteren Aufnahme einer Bestimmung den Punkt bedacht
hätten.

3. Die Kosten dieses Vertrages und der notwendigen Registereintragungen (Gründungskosten) trägt die Gesellschaft

bis zu einem Betrag von EUR 1.700.

4. Alle Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im elektronischen Bundesanzeiger.“

<i>Fünfter Beschluss

Die Gesellschafter akzeptieren den Rücktritt des alleinigen Geschäftsführers Herrn Matthias SPRENKER, beruflich

ansässig in 35, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, mit Wirkung um Mitternacht des Kalendertages vor dem Verle-
gungstag.

Dem bis zum Verlegungstag amtierenden bisherigen Geschäftsführer wird für den Zeitraum, der am Kalendertag vor

dem Verlegungstag endet, Entlastung von seiner Haftung gegenüber der Gesellschaft bezüglich der von ihm ausgeführten
Tätigkeit als Geschäftsführer erteilt.

Zum Verlegungstag übergibt der ausscheidende luxemburgische Geschäftsführer die Geschäftsführung an die unten

benannten neuen Geschäftsführer in Deutschland.

Die Gesellschafter ernennen mit Wirkung ab dem Verlegungstag die folgenden Personen als Geschäftsführer:
a) Herr Dr. Bernd Konrad ITAL, geboren am 03.03.1965 in Mönchengladbach, Deutschland, geschäftsansässig in der

Henkestrasse 10, D-91054 Erlangen; und

b) Herr Felix Sebastian BADER, geboren am 16.06.1981 in Erlangen, Deutschland, geschäftsansässig in der Henkestrasse

10, D-91054 Erlangen.

<i>Sechster Beschluss

Die Gesellschafter bestätigen:
(i) Die Neue Satzung steht im Einklang mit dem Recht der Bundesrepublik Deutschland;
(ii) Die Gesellschaft wird mit Wirkung um Mitternacht des Kalendertages vor dem Verlegungstag aufhören, als lu-

xemburgische  Gesellschaft  zu  existieren,  und  ab  dem  Verlegungstag  dem  anwendbaren  Recht  der  Bundesrepublik
Deutschland unterliegen;

(iii) Die Verlegung des eingetragenen Sitzes der Gesellschaft, die Änderung der Sitzlandes und der Nationalität der

Gesellschaft sowie die Änderung der Gesellschaftsform führen weder zu einer Auflösung und / oder Liquidation der
Gesellschaft noch zur Schaffung einer neuen juristischen Person und erfolgen im Einklang mit allen anwendbaren deutschen
Vorschriften.

<i>Siebenter Beschluss

Dem derzeitigen luxemburgischen Geschäftsführer, dem Rechtsanwalt Marcus PETER mit Sitz in Luxemburg und dem

Wirtschaftsprüfer Wolfgang BLAUBERGER mit Sitz in München wird jeweils einzeln unbeschränkte Vollmacht erteilt
einschließlich des Rechts, Untervollmacht zu erteilen, um die oben genannten Beschlüsse auszuführen und wirksam wer-
den  zu  lassen.  Dazu  gehören  insbesondere  die  Einreichung  von  Unterlagen  beim  deutschen  und  luxemburgischen
Handelsregister.

<i>Achter Beschluss

Die Bücher und Unterlagen, die am bisherigen Sitz der Gesellschaft in Luxemburg verwahrt wurden, werden so bald

wie möglich nach dem Verlegungstag an den oben genannten neuen Sitz der Gesellschaft in Deutschland transferiert.

172064

L

U X E M B O U R G

<i>Bestätigung des Notars über die Kapitalerhöhung

Die gemäß dem ersten Beschluss erfolgte Kapitalerhöhung wird am Tag dieser außerordentlichen Hauptversammlung

wirksam.

Der unterzeichnende Notar bestätigt daher, dass das Kapital der Gesellschaft am Tag dieser notariellen Urkunde

fünfundzwanzigtausend Euro (EUR 25.000,-), aufgeteilt in eintausend (1.000) Anteile zu einem Nominalwert von jeweils
fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-), beträgt.

<i>Kosten

Die aufgrund dieser Versammlung angefallenen Ausgaben, Kosten, Entschädigungen oder Gebühren jeglicher Form,

welche durch die Gesellschaft zu begleichen sind, werden auf ungefähr EUR 2.500,- geschätzt.

Worüber Urkunde aufgenommen wurde in Luxemburg, an dem zu Anfang dieser Urkunde erwähnten Datum.
Nachdem diese Urkunde der anwesenden Person, welche dem unterzeichneten Notar durch Name, Nachname, Fa-

milienstand und Anschrift bekannt ist, vorgelesen wurde, hat die anwesende Person zusammen mit dem Notar diese
Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: C. PFISTER und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 septembre 2014. Relation: LAC/2014/45102. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur

 (signé): I. THILL.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - der Gesellschaft auf Begehr erteilt.

Luxemburg, den 4. November 2014.

Référence de publication: 2014171461/341.
(140195439) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2014.

Synplants Marketing SA, Société Anonyme.

Siège social: L-9706 Clervaux, 4, route de Bastogne.

R.C.S. Luxembourg B 117.103.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fiduciaire ARBO SA
Signature

Référence de publication: 2014171032/11.
(140195052) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2014.

Phoenix II Mixed L, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.000,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 110.514.

Im Jahre zweitausendvierzehn, am neunzehnten September.
Vor Maître Henri HELLINCKX, Notar mit Amtssitz in Luxemburg.

SIND ERSCHIENEN:

die ZBI Invest AG, eine ordnungsgemäß nach deutschem Recht errichtete Aktiengesellschaft mit eingetragenem Sitz

in Henkestrasse 10, D-91054 Erlangen und eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Fürth unter der Nummer
HRB 11315, vertreten durch ihren Vorstand,

und
die Greta 24. Vermögensverwaltungs GmbH, eine ordnungsgemäß nach deutschen Recht errichtete Gesellschaft mit

beschränkter Haftung mit eingetragenem Sitz in Henkestrasse 10, D-91054 Erlangen und eingetragen im Handelsregister
des Amtsgerichts Fürth unter der Nummer HRB 13914, vertreten durch ihre Geschäftsführer,

diese beiden jeweils vertreten durch Claudia PFISTER, Avocat, beruflich ansässig in Luxemburg, per Vollmacht erteilt

am 15. September 2014.

Die vorgenannten Vollmachten werden, nachdem sie „ne varietur” durch den Vertreter der erschienenen Partei und

durch den unterzeichnenden Notar unterschrieben wurden, dieser notariellen Urkunde zum Zweck der Registrierung
beigefügt bleiben.

172065

L

U X E M B O U R G

Die erschienenen Parteien, vertreten wie oben angegeben, haben den unterzeichnenden Notar gebeten, das folgende

festzustellen:

1.) Die ZBI Invest AG und die Greta 24. Vermögensverwaltungs GmbH sind die einzigen Gesellschafter der Phoenix

II  Mixed  L,  einer  Gesellschaft  mit  beschränkter  Haftung  (société  à  responsabilité  limitée),  die  nach  dem  Recht  des
Großherzogtums Luxemburg gegründet wurde, mit eingetragenem Sitz in 35, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, und
eingetragen im luxemburgischen Handels- und Firmenregister unter Nummer B110514, gegründet durch Urkunde des
Notars Jean-Joseph WAGNER, Notar mit Sitz in Sanem, am 9. September 2005, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations (“Mémorial C”) Nr. 12 am 03. Januar 2006, (die “Gesellschaft”). Die Satzung der Gesellschaft
wurde zuletzt geändert durch Urkunde vom 05. August 2013, veröffentlicht im Mémorial C Nr. 2737 am 02. November
2013.

2.) Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500), aufgeteilt in fünf-

hundert (500) Anteile (die «Anteile») zu einem Nominalwert von jeweils fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-). Die Greta 24.
Vermögensverwaltungs GmbH hält 470 Anteile an der Gesellschaft und die ZBI Invest AG hält 30 Anteile an der Gesell-
schaft.

3.) Nachdem dies festgestellt wurde, beschlossen die beiden oben genannten Gesellschafter, welche zusammen das

gesamte Gesellschaftskapital der Gesellschaft vertreten (die „Gesellschafter“), eine außerordentliche Hauptversammlung
abzuhalten.

Die Gesellschafter fassten die folgenden Beschlüsse einstimmig:

<i>Erster Beschluss

Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft wird mit sofortiger Wirkung von seinem derzeitigen Betrag von zwölftau-

sendfundhundert Euro (EUR 12.500,-) um zwölftausendfundhundert Euro (EUR 12.500,-) erhöht, so dass es insgesamt
fünfundzwanzigtausend Euro (EUR 25.000,-), aufgeteilt in eintausend (1.000) Anteile zu einem Nominalwert von jeweils
fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-), beträgt.

<i>Zeichnung und Bezahlung

Hierauf erklärte die vorgenannte Greta 24. Vermögensverwaltungs GmbH, vertreten wie oben angegeben, dass sie

nach Bareinzahlung vierhundertsiebzig (470) weitere Anteile der Gesellschaft zu einem Nominalwert von jeweils fün-
fundzwanzig Euro (EUR 25,-), welche vollständig gezahlt sind, zeichnet.

Des Weiteren erklärte die vorgenannte ZBI Invest AG, vertreten wie oben angegeben, dass sie nach Bareinzahlung

dreißig (30) weitere Anteile der Gesellschaft zu einem Nominalwert von jeweils fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) welche
vollständig gezahlt sind, zeichnet.

Die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) steht der Gesellschaft ab sofort zur freien Verfügung,

so wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde.

<i>Zweiter Beschluss

Die Satzung der Gesellschaft wird infolge der oben aufgeführten Beschlüsse geändert, um deren Inhalt in der Satzung

ordnungsgemäß widerzuspiegeln.

Artikel 6 der englischen Fassung der Satzung erhält nunmehr folgenden Wortlaut:

“ Art. 6. The Company's share capital is set at twenty-five thousand euro (EUR 25,000) represented by one thousand

(1,000) shares with a par value of one twenty-five euro (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.”
Artikel 6 der französischen Fassung der Satzung erhält folgenden Wortlaut:

“ Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-) représenté par mille (1.000)

parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.”

<i>Dritter Beschluss

Der eingetragene Sitz der Gesellschaft wird mit Wirkung zum Verlegungstag von 35, avenue Monterey, L-2163 Lu-

xembourg, Großherzogtum Luxemburg, nach Henkestrasse 10, D-91054 Erlangen verlegt.

Durch den Wegzug der Gesellschaft nach Deutschland wird, ohne Aufgabe der Rechtspersönlichkeit der Gesellschaft,

die luxemburgische Nationalität der Gesellschaft in die deutsche Nationalität geändert. Diese Verlegung erfolgt im Einklang
mit Artikel 18 Absatz 2 der Satzung der Gesellschaft und Artikel 199 der aktuellen Fassung des luxemburgischen Gesetzes
vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften durch einstimmigen Beschluss sämtlicher Gesellschafter.

Der Wegzug und die Abänderung der Nationalität wie oben beschrieben sollen an jenem Tag Wirksamkeit erlangen,

an dem die Gesellschaft in das zuständige deutsche Handelsregister eingetragen wird („Verlegungstag“).

Die Gesellschaft und ihre Geschäftsführer werden sämtliche Dokumente einreichen, die notwendig sind, um diesem

Beschluss nach deutschem Recht Wirkung zu verschaffen.

172066

L

U X E M B O U R G

<i>Vierter Beschluss

Die Gesellschaftsform der Gesellschaft wird mit Wirkung zum Verlegungstag von einer luxemburgischen Gesellschaft

mit beschränkter Haftung zu einer deutschen Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt, welche deutschem
Recht und insbesondere dem Gesetz für Gesellschaften mit beschränkter Haftung (“GmbHG”) unterliegt und die folgende
den Bestimmungen des deutschen Rechts und des GmbHG entsprechende vollständig neu gefasste Satzung (die „Neue
Satzung“) hat:

„Gesellschaftsvertrag der Phoenix II Mixed L GmbH

§ 1. Firma und Sitz.
1. Die Firma der Gesellschaft lautet:
Phoenix II Mixed L GmbH
- nachstehend Gesellschaft genannt -2. Der Sitz der Gesellschaft ist Erlangen.

§ 2. Gegenstand des Unternehmens.
1. Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung und Bewirtschaftung von eigenen Immobilienvermögen.
2. Die Gesellschaft darf alle Maßnahmen treffen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern.

§ 3. Stammkapital, Stammeinlage.
1. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt fünfundzwanzigtausend Euro (EUR 25.000,-).
2. Das Stammkapital ist eingeteilt in eintausend Geschäftsanteile mit den laufenden Nummern von 1 bis 1.000 mit den

jeweils nachstehenden genannten Nennbeträgen. Hierauf übernehmen:

- Greta 24. Vermögensverwaltungs GmbH neunhundertvierzig (940) Geschäftsanteile im Nennwert von je EUR 25,00

(lfd. Nr. 1 bis 940)

- ZBI Invest AG sechzig (60) Geschäftsanteile im Nennwert von je EUR 25,00 (lfd. Nr. 941 bis 1.000)
3. Die Geschäftsanteile sind in Geld einzuzahlen.
4. Mehrere voll eingezahlte Geschäftsanteile eines Gesellschafters können durch Gesellschafterbeschluss bei Zustim-

mung des betroffenen Gesellschafters zu einem einheitlichen Geschäftsanteil zusammengelegt werden.

§ 4. Geschäftsführung, Vertretung.
1. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, die von der Gesellschafterversammlung berufen und

abberufen werden. Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so ist er stets alleinvertretungsberechtigt. Sind mehrere Ge-
schäftsführer  vorhanden,  so  wird  die  Gesellschaft  jeweils  von  zwei  Geschäftsführern  gemeinsam  oder  von  einem
Geschäftsführer und einem Prokuristen vertreten. Auch wenn mehrere Geschäftsführer vorhanden sind, kann einem oder
mehreren Geschäftsführern das Recht zur Alleinvertretung verliehen werden.

2. Die Gesellschafterversammlung kann Geschäftsführer von den Beschränkungen des § 181 BGB generell befreien.
3. Haftungsmaßstab für die Geschäftsführung ist die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes.
4. Die Geschäftsführung hat alle Regeln und Beschränkungen des Gesellschaftsvertrages zu beachten. Investitionen in

Immobilien bedürfen eines Gesellschafterbeschlusses gemäß den Regelungen in § 5 dieser Satzung.

5. Die Geschäftsführung ist ermächtigt, der ZBI Zentral Boden Immobilien AG oder einer anderen Gesellschaft der

ZBI Zentral Boden Immobilien-Gruppe, an jedem für Investitionszwecke angeschafften Grundstück, unter Befreiung von
§ 181 BGB, ein unwiderrufliches schuldrechtliches und/oder dingliches Vorkaufsrecht einzuräumen.

6.  Die  Geschäftsleitung  ist  ermächtigt,  freie  Liquidität  mittelbar  oder  unmittelbar  nach  freiem  Ermessen  auf  cash-

Konten, auf Festgeldkonten oder in festverzinslichen Wertpapieren mit einem Rating von mindestens AA (Standard &amp;
Poor's, Moody's oder Fitch Ratings) anzulegen.

§ 5. Investitionsbeschlüsse und Mittelverwendungskontrolle, Kosten.
1. Die Gesellschaft wird nur über solche mittelbaren und unmittelbaren Immobilien Investitionsvorschläge beschließen,

die die ZBI Zentral Boden Immobilien GmbH &amp; Co. Siebte Professional Immobilien Holding KG vorher durch wirksamen
Beschluss der Gesellschafterversammlung oder deren Beirat für kaufenswert befunden hat.

2. Die Freigabe der Investitionsmittel für Immobilieninvestitionen unterliegt der Mittelverwendungskontrolle und rich-

tet sich nach den einschlägigen Vorschriften des Mittelverwendungskontrollvertrages zwischen der ZBI Zentral Boden
Immobilien GmbH &amp; Co. Siebte Professional Immobilien Holding KG und der Treuhand GmbH Franken, dem die Ge-
sellschaft hiermit beitritt.

3. Die Geschäftsführung hat folgende vom Mittelverwendungskontrolleur benötigten Unterlagen vorzubereiten und

zur Verfügung zu stellen:

- Kaufvertrag.
- Grundbuchauszug.
- Gegebenenfalls Altlastengutachten, gegebenenfalls Bodengutachten, gegebenenfalls Holzschutz- und Feuchtigkeitsgu-

tachten.

- Gegebenenfalls Verträge für Dienstbarkeiten.

172067

L

U X E M B O U R G

- Gegebenenfalls Teilungserklärungen oder Unterlagen zur Grundstücksvereinigung.
- Protokoll über eventuell bestehende Baumängel.
- Gegebenenfalls Verwaltervertrag.
- Die Satzung oder den Gesellschaftsvertrag einer zu kaufenden Gesellschaft inklusive aller Nachträge und einen ak-

tuellen Handelsregisterauszug.

- Die Satzung oder den Gesellschaftsvertrag der kaufenden Objektgesellschaft inklusive aller Nachträge und einen

aktuellen Handelsregisterauszug.

- Bei Gewerbeobjekten Mietverträge über mindestens 80,00 % der Mietfläche oder mindestens Kapitaldienst deckend

für die Fremdmittel; bei Wohnobjekten vollständige Mieterlisten und stichprobenweise einzelne Mietverträge.

- Das Grundstück und die Immobilie sind im Erwerbsvorgang lastenfrei zu stellen außer den Belastungen in Abteilung

III, die in Anrechnung auf den Kaufpreis übernommen werden und in Abteilung II, die nicht als wertmindernde Rechte
angesehen werden.

- Technische und kaufmännische Due-Diligence-Prüfung.
- Bei investmentnahen Ausbauten, Umbauten, Sanierungen und Modernisierungen eine schlüssige Gesamtkalkulation

der Geschäftsleitung über die hierfür zu erwartenden Kosten.

4. Die Gesellschaft trägt die Kosten im Sinne von § 12 des Gesellschaftsvertrages der ZBI Zentral Boden Immobilien

GmbH &amp; Co. Siebte Professional Immobilien Holding KG, die mit ihren Immobilieninvestitionen in Zusammenhang stehen,
als eigene Kosten.

§ 6. Gesellschafterbeschlüsse.
1. Die Geschäftsführung hat alljährlich nach Vorliegen des Jahresabschlusses unter Wahrung einer Ladungsfrist von

zwei Wochen, unter Angabe der Tagesordnung und unter Übersendung einer Abschrift des Jahresabschlusses zu einer
ordentlichen Gesellschafterversammlung einzuladen.

2. Beschlüsse der Gesellschafterversammlung sind in allen Angelegenheit der Gesellschaft zulässig. Sie werden, sofern

im Gesellschaftsvertrag oder im Gesetz nichts anderes bestimmt ist, mit einfacher Stimmenmehrheit der Erschienenen
gefasst. Je EUR 25 eines Gesellschaftsanteils gewähren eine Stimme.

3. Die Gesellschafter beschließen insbesondere über:
a) Die von der Geschäftsführung vorzulegenden Immobilienmodernisierungskonzepte.
b) Die durchzuführenden Investitionen gemäß den Vorschlägen der Geschäftsführung auf der Grundlage der vorge-

legten Investitionspläne.

c) Abschluss, Änderung und Beendigung von Dauerschuldverhältnissen, insbesondere Darlehensverträge, Mietverträge,

Pachtverträge und Leasingverträge, soweit dies nicht mit den Investitionen der Gesellschaft und dem dafür benötigten
mittelbaren oder unmittelbaren Fremdkapital in Zusammenhang steht.

d) Die Aufnahme von Fremdwährungsdarlehen, ausgenommen Fremdwährungsdarlehen in Schweizer Franken (CHF),

wenn diese Fremdwährungsdarlehen insgesamt max. 25,00 % aller jeweils am Tage der Unterzeichnung des Darlehens-
vertrages zugesagten konsolidierten Fremdmittel der Gesellschaft und der Objektschwestergesellschaften betragen.

e) Die Feststellung des Jahresabschlusses, die Entnahmen sowie die Entlastung des oder der Geschäftsführer(s) für das

abgelaufene Geschäftsjahr.

f) Die Führung von Aktivprozessen und prozessbeendende Handlungen und Erklärungen ab einem Streitwert von EUR

500.000.

g) Den Verkauf von Immobilien der Gesellschaft, soweit diese mit einem Handelsgewinnaufschlag (nach Abzug der

Courtage für den/die Verkaufsmakler) von weniger als 15,00 % auf den Gestehungspreis gemäß § 5 Absatz 2 des Gesell-
schaftsvertrages der ZBI Zentral Boden Immobilien GmbH &amp; Co. Siebte Professional Immobilien Holding KG veräußert
werden sollen.

h) Änderungen des Gesellschaftsvertrages.
i) Die Umwandlung der Gesellschaft gemäß § 1 UmwG.
j) Eine evtl. Notierung (Listung) an der Börse und/oder Börsengang der Gesellschaft (IPO).
k) Die Annahme von Generalunternehmer-Angeboten oder die Einzelvergabe der Gewerke.
Über Maßnahmen gem. lit. h) bis j) beschließt die Gesellschafterversammlung mit einer Mehrheit von dreiviertel der

abgegebenen Stimmen.

4. Beschließen die Gesellschafter über Investitionen oder über andere Angelegenheiten, die der Mittelverwendungs-

kontrolle unterliegen, so werden sie den § 5 beachten.

5. Gesellschafterbeschlüsse können, vorbehaltlich zwingender gesetzlicher Formvorschriften, wenn alle Gesellschafter

mit diesem Verfahren einverstanden sind, auch fernschriftlich durch Telex oder Telefax oder schriftlich ohne förmliche
Gesellschafterversammlung gefasst werden.

§ 7. Auskunfts- und Einsichtsrechte. Die Gesellschafter haben jederzeit das Recht, die Unterlagen der Gesellschaft

einzusehen.

172068

L

U X E M B O U R G

§ 8. Jahresabschluss.
1. Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind von der Geschäftsführung innerhalb der gesetzlichen Frist

aufzustellen und von den Gesellschaftern festzustellen. Für die Aufstellung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlus-
trechnung gelten die gesetzlichen Bestimmungen und die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung.

2. Die Geschäftsführung hat die Aufstellung des Abschlusses durch einen Wirtschaftsprüfer zu veranlassen mit der

Maßgabe, dass im Rahmen der Aufstellung Prüfungshandlungen vorgenommen und Bericht erstattet wird. Die Gesell-
schafterversammlung kann beschließen, stattdessen den Jahresabschluss einem Wirtschaftsprüfer oder einer Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft zur vollumfänglichen Prüfung vorzulegen.

3. Eine Abschrift des Jahresabschlusses nebst Prüfungsvermerk oder Bescheinigung des Wirtschaftsprüfers oder Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaft ist allen Gesellschaftern zuzuleiten. Dem Mittelverwendungskontrolleur ist der Prüfungsbe-
richt bzw. der ihn ersetzende Bericht über die Aufstellung des Jahresabschlusses zu übermitteln.

§ 9. Geschäftsführervergütung. Die Gesellschaft ist nicht zur Zahlung einer Geschäftsführervergütung verpflichtet. Die

Tätigkeiten des Geschäftsführers werden nicht entgolten.

§ 10. Verteilung des Jahresergebnisses.
1. Über die Verwendung des Jahresergebnisses (Summe aus Jahresüberschuss und Gewinnvortrag abzüglich Verlust-

vortrag) oder - soweit einschlägig - über die Verwendung des Bilanzgewinnes entscheiden die Gesellschafter spätestens
bis zum Ablauf der ersten sechs Monate des Geschäftsjahres mit einfacher Mehrheit.

2. Die Gewinnausschüttung hat binnen einer Frist von 4 Wochen -gerechnet ab Beschlussfassung - zu erfolgen.

§ 11. Dauer der Gesellschaft. Die Gesellschaft ist grundsätzlich auf unbestimmte Zeit errichtet. Sie wird aufgelöst mit

Veräußerung der letzten gehaltenen Immobilie, jedoch nicht vor dem 31. Dezember 2022.

§ 12. Kündigung und Ausscheiden aus der Gesellschaft.
1. Die ordentliche Kündigung des Gesellschaftsvertrages ist ausgeschlossen. Das Recht zur fristlosen Kündigung aus

wichtigem  Grund  bleibt  unberührt.  Durch  die  Kündigung  eines  Gesellschafters  wird  die  Gesellschaft  nicht  aufgelöst,
vielmehr scheidet der kündigende Gesellschafter aus der Gesellschaft aus.

2. Wird ein Gesellschafter zahlungsunfähig, wird über sein Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet oder dessen

Eröffnung mangels Masse abgelehnt, so scheidet der betreffende Gesellschafter mit sofortiger Wirkung aus der Gesell-
schaft - auch wenn diese bereits ihre Auflösung beschlossen hat -aus, ohne dass es eines Gesellschafterbeschlusses oder
einer gerichtlichen Klage bedarf.

3. Wird gegen einen Gesellschafter oder sein Vermögen eine Maßnahme der Zwangsvollstreckung aus einem nicht nur

vorläufig vollstreckbaren Titel in seinen Gesellschaftsanteil eingeleitet, so scheidet der betreffende Gesellschafter nach
Ablauf von vier Wochen, gerechnet vom Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Zwangsvollstreckung an, aus der Gesell-
schaft - auch wenn diese bereits ihre Auflösung beschlossen hat - aus, wenn nicht die Zwangsvollstreckungsmaßnahme
innerhalb dieser Frist aufgehoben wird.

4. Ein Gesellschafter, der Klage auf Auflösung der Gesellschaft erhebt, scheidet mit Rechtshängigkeit der Klage aus der

Gesellschaft aus, die auch in diesem Falle von den verbleibenden Gesellschaftern fortgesetzt wird.

5. Ein Gesellschafter kann aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden, wenn in seiner Person ein wichtiger Grund

gegeben ist. Der ausscheidende Gesellschafter hat bei der Beschlussfassung kein Stimmrecht.

6. Der aufgrund der Kündigung oder durch Ausschluss ausscheidende Gesellschafter erhält eine Abfindung gemäß §

13.

7. Der ausscheidende Gesellschafter ist sodann verpflichtet, nach Wahl der Gesellschaft seinen Anteil (ganz oder

geteilt) an die Gesellschaft selbst, an einen oder mehrere Gesellschafter oder an einen oder mehrere von der Gesellschaft
zu benennende Dritte abzutreten oder die Einziehung seines Anteils zu dulden.

§ 13. Abfindung.
1. Scheidet ein Gesellschafter aus der Gesellschaft aus, erhält er für seine Beteiligung am Gesellschaftsvermögen eine

Abfindung in Geld. Die Abfindung errechnet sich im Falle des Ausscheiden aufgrund der Regelungen in § 12 Absatz 2 - 5
oder aufgrund eines vom ausscheidenden Gesellschafter zu vertretenden Kündigungsgrundes sowie im Falle des Auss-
chlusses wegen nicht vollständig oder nicht gehörig geleisteter Einlage nach Absatz 2, in allen anderen Fällen gemäß Absatz
3.

2. Der Gesellschafter erhält ein Abfindungsguthaben in Höhe des Buchwertes seiner Beteiligung nach dem Stande vom

31.12. des dem Ausscheiden vorangehenden Kalenderjahres, höchstens aber den Betrag der von ihm geleisteten Einlage,
jeweils abzüglich zwischenzeitlicher Entnahmen, zuzüglich des anteiligen Gewinnes und abzüglich eines etwaigen anteiligen
Verlustes.

3. Der Gesellschafter erhält ein Abfindungsguthaben in Höhe des Verkehrswertes seiner Beteiligung. Hierzu werden

die beweglichen Wirtschaftsgüter der Gesellschaft mit einem anhand einschlägiger Listen oder Indizes zu schätzenden
Teilwert angesetzt, der Grundbesitz bei einem Ausscheiden während der Geschäftsjahre 2012 bis einschließlich 2015 mit
dem 12,0-fachen der durchschnittlich für die vorausgegangenen drei Kalenderjahre erzielten Jahresnettomiete (ohne Ne-
benkosten und Mehrwertsteuer), bei einem Ausscheiden während der Geschäftsjahre 2016 ff. mit dem 13,0-fachen der

172069

L

U X E M B O U R G

durchschnittlich für die vorausgegangenen drei Kalenderjahre erzielten Jahresnettomiete (ohne Nebenkosten und Mehr-
wertsteuer) bzw. jeweils maximal mit 20,00 % über dem jeweils ursprünglich bezahlten Einkaufspreis im Sinne des § 5
Absatz 2 UA 4 des Gesellschaftsvertrages der ZBI Zentral Boden Immobilien GmbH &amp; Co. Siebte Professional Immobilien
Holding KG. Die durch das Ausscheiden des Gesellschafters bedingten Kosten und Abgaben sind in Abzug zu bringen.
Ein Geschäftswert wird nicht angesetzt. Das Ergebnis schwebender Geschäfte wird nicht berücksichtigt. Der Abfindungs-
betrag wird von dem für die Gesellschaft tätigen Steuerberater gemäß § 317 BGB auf den Tag des Ausscheidens ermittelt,
wobei, falls zwischen der Gesellschaft und dem ausscheidenden Gesellschafter keine Einstimmigkeit über das Auseinan-
dersetzungsguthaben erzielt werden kann, das Auseinandersetzungsguthaben des ausscheidenden Gesellschafters durch
das Gutachten eines anderen Wirtschaftsprüfers als Schiedsgutachter nach billigem Ermessen festzustellen ist. Die Ent-
scheidung des Schiedsgutachters ist für die Gesellschaft und den ausscheidenden Gesellschafter verbindlich. Können die
Parteien sich nicht auf einen Wirtschaftsprüfer einigen, hat auf den Antrag einer der Parteien die Wirtschaftsprüferkammer
einen Wirtschaftsprüfer zu benennen. Die Kosten des Gutachters tragen die Parteien unter entsprechender Anwendung
des § 91 Absatz 1 ZPO. Über die Kostentragung entscheidet der Schiedsgutachter.

4. Das Abfindungsguthaben ist mit Wirksamwerden des Ausscheidens des Gesellschafters in einem Betrag zur Zahlung

fällig.

5. Sicherheitsleistung für die Zahlung des Abfindungsguthabens kann der ausscheidende Gesellschafter nicht verlangen.

§ 14. Liquidation.
1. Die Liquidation erfolgt durch den oder die Geschäftsführer.
2. Über eine Liquidationsvergütung beschließt die Gesellschafterversammlung.
3. Das nach Befriedigung der Gläubiger verbleibende Vermögen der Gesellschaft wird nach dem Verhältnis der Ge-

schäftsanteile verteilt.

§ 15. Erfüllungsort. Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle sich aus diesem Vertrag oder aufgrund dieses Vertrages

ergebenden Ansprüche ist - soweit gesetzlich zulässig - Erlangen.

§ 16. Wettbewerbsverbot. Die Geschäftsführer und die Gesellschafter sind vom Wettbewerbsverbot befreit. Sofern

ein Geschäftsführer einem Wettbewerbsverbot unterliegen soll, wird dieses im jeweiligen Anstellungsvertrag geregelt.

§ 17. Schlussbestimmungen.
1. Nebenabreden. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages sowie alle das Gesellschaftsverhältnis betreffenden

Vereinbarungen der Gesellschafter untereinander und mit der Gesellschaft bedürfen der Schriftform, soweit nicht kraft
zwingenden Gesetzes eine strengere Form vorgeschrieben ist. Auf das Schriftformerfordernis kann nur schriftlich ver-
zichtet werden.

2. Sollten Bestimmungen dieses Vertrages oder eine künftig in ihm aufgenommene Bestimmung ganz oder teilweise

nicht rechtswirksam oder nicht durchführbar sein oder ihre Rechtswirksamkeit oder Durchführbarkeit später verlieren,
so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen des Vertrages nicht berührt. Das gleiche gilt, soweit sich
herausstellen sollte, dass der Vertrag eine Regelungslücke enthält. Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren
Bestimmungen oder zur Ausfüllung der Lücke soll eine angemessene Regelung gelten, die, soweit rechtlich möglich, dem
am nächsten kommt, was die Gesellschafter gewollt haben oder nach dem Sinn und Zweck des Vertrages gewollt haben
würden, sofern sie bei Abschluss dieses Vertrages oder bei der späteren Aufnahme einer Bestimmung den Punkt bedacht
hätten.

3. Die Kosten dieses Vertrages und der notwendigen Registereintragungen (Gründungskosten) trägt die Gesellschaft

bis zu einem Betrag von EUR 1.700.

4. Alle Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im elektronischen Bundesanzeiger.“

<i>Fünfter Beschluss

Die Gesellschafter akzeptieren den Rücktritt des alleinigen Geschäftsführers Herrn Matthias SPRENKER, beruflich

ansässig in 35, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, mit Wirkung um Mitternacht des Kalendertages vor dem Verle-
gungstag.

Dem bis zum Verlegungstag amtierenden bisherigen Geschäftsführer wird für den Zeitraum, der am Kalendertag vor

dem Verlegungstag endet, Entlastung von seiner Haftung gegenüber der Gesellschaft bezüglich der von ihm ausgeführten
Tätigkeit als Geschäftsführer erteilt.

Zum Verlegungstag übergibt der ausscheidende luxemburgische Geschäftsführer die Geschäftsführung an die unten

benannten neuen Geschäftsführer in Deutschland.

Die Gesellschafter ernennen mit Wirkung ab dem Verlegungstag die folgenden Personen als Geschäftsführer:
a) Herr Dr. Bernd Konrad ITAL, geboren am 03.03.1965 in Mönchengladbach, Deutschland, geschäftsansässig in der

Henkestrasse 10, D-91054 Erlangen; und

b) Herr Felix Sebastian BADER, geboren am 16.06.1981 in Erlangen, Deutschland, geschäftsansässig in der Henkestrasse

10, D-91054 Erlangen.

172070

L

U X E M B O U R G

<i>Sechster Beschluss

Die Gesellschafter bestätigen:
(i) Die Neue Satzung steht im Einklang mit dem Recht der Bundesrepublik Deutschland;
(ii) Die Gesellschaft wird mit Wirkung um Mitternacht des Kalendertages vor dem Verlegungstag aufhören, als lu-

xemburgische  Gesellschaft  zu  existieren,  und  ab  dem  Verlegungstag  dem  anwendbaren  Recht  der  Bundesrepublik
Deutschland unterliegen;

(iii) Die Verlegung des eingetragenen Sitzes der Gesellschaft, die Änderung der Sitzlandes und der Nationalität der

Gesellschaft sowie die Änderung der Gesellschaftsform führen weder zu einer Auflösung und / oder Liquidation der
Gesellschaft noch zur Schaffung einer neuen juristischen Person und erfolgen im Einklang mit allen anwendbaren deutschen
Vorschriften.

<i>Siebenter Beschluss

Dem derzeitigen luxemburgischen Geschäftsführer, dem Rechtsanwalt Marcus PETER mit Sitz in Luxemburg und dem

Wirtschaftsprüfer Wolfgang BLAUBERGER mit Sitz in München wird jeweils einzeln unbeschränkte Vollmacht erteilt
einschließlich des Rechts, Untervollmacht zu erteilen, um die oben genannten Beschlüsse auszuführen und wirksam wer-
den  zu  lassen.  Dazu  gehören  insbesondere  die  Einreichung  von  Unterlagen  beim  deutschen  und  luxemburgischen
Handelsregister.

<i>Achter Beschluss

Die Bücher und Unterlagen, die am bisherigen Sitz der Gesellschaft in Luxemburg verwahrt wurden, werden so bald

wie möglich nach dem Verlegungstag an den oben genannten neuen Sitz der Gesellschaft in Deutschland transferiert.

<i>Bestätigung des Notars Über die Kapitalerhöhung

Die gemäß dem ersten Beschluss erfolgte Kapitalerhöhung wird am Tag dieser außerordentlichen Hauptversammlung

wirksam.

Der unterzeichnende Notar bestätigt daher, dass das Kapital der Gesellschaft am Tag dieser notariellen Urkunde

fünfundzwanzigtausend Euro (EUR 25.000,-), aufgeteilt in eintausend (1.000) Anteile zu einem Nominalwert von jeweils
fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-), beträgt.

<i>Kosten

Die aufgrund dieser Versammlung angefallenen Ausgaben, Kosten, Entschädigungen oder Gebühren jeglicher Form,

welche durch die Gesellschaft zu begleichen sind, werden auf ungefähr EUR 2.500,- geschätzt.

Worüber Urkunde aufgenommen wurde in Luxemburg, an dem zu Anfang dieser Urkunde erwähnten Datum.
Nachdem diese Urkunde der anwesenden Person, welche dem unterzeichneten Notar durch Name, Nachname, Fa-

milienstand und Anschrift bekannt ist, vorgelesen wurde, hat die anwesende Person zusammen mit dem Notar diese
Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: C. PFISTER und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 septembre 2014. Relation: LAC/2014/45099. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - der Gesellschaft auf Begehr erteilt.

Luxemburg, den 4. November 2014.

Référence de publication: 2014171459/339.
(140195433) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2014.

Lungo Mare S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 147.436.

In the year two thousand and fourteen.
On the twentieth day of October.
Before Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg).

Is held

an extraordinary general meeting of the shareholders of the public limited company "Lungo Mare S.A.", with registered

office at L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, registered with the Luxembourg trade registry, section B, under
the number 147436, incorporated by a deed received by Maître Francis KESSELER, notary residing in Esch-sur-Alzette

172071

L

U X E M B O U R G

(Grand-Duchy of Luxembourg), dated July 7, 2009, published in the Mémorial C number 1637 of August 25, 2009 (the
"Company").

The corporate capital amounts to thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) represented by three hundred and ten

(310) shares with a nominal value of one hundred euro (EUR 100.-) each.

The meeting is presided by Mr. Bob PLEIN, employee, residing professionally in Junglinster, 3, route de Luxembourg,

(Grand-Duchy of Luxembourg).

The chairman appoints as secretary Mr. Henri DA CRUZ, employee, residing professionally in Junglinster, 3, route de

Luxembourg, (Grand-Duchy of Luxembourg).

The meeting elects as scrutineer Mr. Max MAYER, employee, residing professionally in Junglinster, 3, route de Lu-

xembourg, (Grand-Duchy of Luxembourg).

The board having thus been formed the chairman states and asks the notary to enact:
That the represented shareholder, the attorney of the represented shareholder as well as the number of shares are

indicated on an attendance list, which after having been checked and signed by the attorney of the represented share-
holder, the members of the board of the meeting and the undersigned notary, shall be kept at the latter’s office.

The proxy of the represented shareholder, after having been signed “ne varietur” by the appearing parties and the

undersigned notary, shall remain annexed to this document and shall be filed at the same time with the registration
authorities.

It results from the said attendance list that all the issued shares are represented, so that the present meeting is regularly

constituted and may validly deliberate upon the points of the agenda, which reads as follows:

<i>Agenda:

1. Resolution to dissolve the Company and to liquidate its assets.
2. Appointment of NOETRIB ADMINISTRATION S.A., a public limited company having its registered office at L-2212

Luxembourg, 6, Place de Nancy, registered with the Luxembourg trade registry, section B, under the number 74 517, as
liquidator with the broadest power mentioned in the articles 144 to 148 of the amended Corporate Act of August 10,
1915.

3. Discharge to the directors and to the supervisory auditor for the performance of their respective mandates.
After deliberation, the following resolutions were taken by the meeting by unanimous vote.

<i>First resolution

The meeting decides to dissolve the Company and to liquidate its assets.

<i>Second resolution

The meeting decides to appoint as liquidator of the Company:
NOETRIB ADMINISTRATION S.A., a public limited company having its registered office at L-2212 Luxembourg, 6,

Place de Nancy, registered with the Luxembourg trade registry, section B, under the number 74517.

The liquidator shall have the broadest powers to carry out its mandate, in particular all the powers provided for by

articles 144 to 148 of the amended Corporate Act of August 10, 1915, concerning commercial companies, without having
to ask for authorization of the general meeting of shareholders in the cases provided for by law.

<i>Third resolution

The meeting gives full discharge to the directors, namely, Ms. Katia CAMBON, chairwoman of the board of directors,

Mr. Franck BETH and Mr. Sébastien ANDRE, and to the supervisory auditor of the Company, namely the private limited
company "COMCOLUX S.à r.l.", for the performance of their respective mandates.

<i>Costs

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed

are estimated at EUR 1,000.-.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that at the request of the

attorney the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same attorney, in case
of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg), on the day named

at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

first names, civil status and residences, they signed together with us, the notary, the present original deed.

172072

L

U X E M B O U R G

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze.
Le vingt octobre.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie

l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "Lungo Mare S.A.", avec siège à L-2453 Luxembourg, 6, rue

Eugène Ruppert, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 147436,
constituée suivant acte reçu par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de
Luxembourg), en date du 7 juillet 2009, publié au Mémorial C numéro 1637 du 25 août 2009 (la "Société").

Le capital social s’élève à trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) représenté par trois cent dix (310) actions d’une

valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

L'assemblée est présidée par Monsieur Bob PLEIN, employé, demeurant professionnellement à Junglinster, 3, route

de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Henri DA CRUZ, employé, demeurant professionnellement à Jun-

glinster, 3, route de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Max MAYER, employé, demeurant professionnellement à Junglinster,

3, route de 4 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Le bureau ayant ainsi été constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:
Que l’actionnaire représenté, le mandataire de l’actionnaire représenté et le nombre d'actions ont été portés sur une

liste de présence, laquelle, contrôlée et signée par le mandataire de l’actionnaire représenté, les membres du bureau de
l’assemblée, et par le notaire instrumentant, sera conservée à l’étude de celui-ci.

La procuration de l’actionnaire représenté, après avoir été signée «ne varietur» par les comparants et le notaire

instrumentant, demeurera annexée au présent acte lequel elle sera enregistrée.

Il résulte de ladite liste de présence que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement

constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour, qui est conçu
comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Résolution de dissoudre la Société et de liquider ses avoirs.
2. Nomination de NOETRIB ADMINISTRATION S.A., une société anonyme ayant son siège au L-2212 Luxembourg,

6, Place de Nancy, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 74 517,
comme liquidateur avec les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 de la loi modifiée sur les sociétés
commerciales du 10 août 1915.

3. Décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leurs mandats respectifs.
Après délibération, l’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de dissoudre la Société et de liquider ses avoirs.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de nommer comme liquidateur de la Société:
NOETRIB ADMINISTRATION S.A., une société anonyme ayant son siège au L-2212 Luxembourg, 6, Place de Nancy,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 74517.

Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus étendus pour exécuter son mandat, et notamment par les articles 144

à 148 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée
générale dans le cas où cette autorisation est normalement requise.

<i>Troisième résolution

L'assemblée donne décharge pleine et entière aux administrateurs, à savoir Madame Katia CAMBON, présidente du

conseil d’administration, Monsieur Franck BETH et Monsieur Sébastien ANDRE, et au commissaire de la Société, à savoir
la société à responsabilité limitée «COMCOLUX S.à r.l.», pour l’exécution de leurs mandats respectifs.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la Société en raison des présentes s'élève

approximativement à 1.000,-EUR.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

172073

L

U X E M B O U R G

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais et le français, constate par les présentes qu'à la requête du man-

dataire, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française, à la requête du même mandataire et en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leur nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Bob PLEIN, Henri DA CRUZ, Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 23 octobre 2014. Relation GRE/2014/4130. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2014168507/127.
(140191996) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2014.

MCT Berlin Vier S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 5, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 120.529.

In the year two thousand and fourteen, on the twelfth day of the month of September;
Before the undersigned notary Carlo WERSANDT, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg);

Is held

an extraordinary general meeting of the shareholders (the “Meeting“) of the public limited company (“Aktiengesell-

schaft”) “MCT BERLIN VIER S.A.“, with registered office in L-2163 Luxembourg, 5, avenue Monterey, registered with
the Trade and Companies Register of Luxembourg, section B, under the number 120529, (hereafter the “Company”),
incorporated pursuant to a deed of the notary Henri HELLINCKX, then residing in Mersch (Grand Duchy of Luxembourg),
on September 27, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2251 of December
1, 2006,

and whose articles of association (the “Articles”) have been amended pursuant to a deed of the notary Jean-Joseph

WAGNER, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg), on September 25, 2009, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, number 2082 of October 22, 2009.

The Meeting is opened by Mr. Jean-Paul SCHAUL, licencié en sciences économiques appliquées, residing professionally

in L-2163 Luxembourg, 5, avenue Monterey (Grand Duchy of Luxembourg), being in the chair.

The Chairman appoints as secretary and the Meeting elects as scrutineer Mr. Christian DOSTERT, employee, residing

professionally in L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

The board of the Meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state the

following:

A) That the agenda of the Meeting is the following:

<i>Agenda

1. Amendment of the second paragraph of article 5 of the by-laws;
2. Miscellaneous.
B) That the shareholders present or represented, as well as the number of the shares held by them, are shown on an

attendance list; this attendance list is signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders, the mem-
bers of the board of the Meeting and the officiating notary.

C) That the proxies of the represented shareholders, signed “ne varietur” by the members of the board of the Meeting

and the officiating notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.

D) That the whole corporate capital is present or represented at the present Meeting and that all the present or

represented shareholders declare having had due notice and got knowledge of the agenda prior to this Meeting.

No other convening notices were necessary.
E) That the present Meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deli-

berate on all the items on the agenda.

Then the Meeting, after deliberation, has taken unanimously the following resolution:

<i>Resolution

The Meeting resolves to amend the second paragraph of article 5 of the Articles, relating to the existence of a share

premium account, and to give it henceforth the following wording:

172074

L

U X E M B O U R G

“In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account, into which any premium paid on any

share is transferred. The amount of said premium account is at the free disposal of the shareholder(s).”

There being no further business on the agenda, the Chairman thereupon has closed the Meeting.

<i>Expenses

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately 905.- EUR.

<i>Statement

The undersigned notary, who speaks and understands English and German, states herewith that the present deed is

worded in English followed by a German version; on request of the appearing persons and in case of divergences between
the English and the German version, the English version will be prevailing.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The deed having been read to the appearing persons, known to the officiating notary by their first and last name, civil

status and residence, the said appearing persons have signed together with Us the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Fassung des vorangegangenen Textes:

Im Jahre zweitausendvierzehn, am zwölften Tag des Monats September;
Vor dem unterzeichneten Notar Carlo WERSANDT, mit dem Amtssitz in Luxembourg (Großherzogtum Luxemburg);
Wird ein außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre (die „Versammlung“) der Aktiengesellschaft „MCT

BERLIN VIER S.A.“, mit Sitz in L-2163 Luxemburg, 5, Avenue Monterey, eingetragen beim Handels- und Gesellschafts-
register von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 120529, (hiernach die „Gesellschaft“), gegründet gemäß Urkunde
aufgenommen durch Notar Henri HELLINCKX, mit dem damaligen Amtssitz in Mersch (Großherzogtum Luxemburg),
am  27.  September  2006,  veröffentlicht  im  Mémorial  C,  Recueil  des  Sociétés  et  Associations,  Nummer  2251  vom  1.
Dezember 2006,

und deren Statuten (die „Statuten“) sind abgeändert worden gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Jean-Joseph

WAGNER, mit dem Amtssitz in Sassenheim (Großherzogtum Luxemburg), am 25. September 2009, veröffentlicht im
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 2082 vom 22. Oktober 2009.

Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Herrn Jean-Paul SCHAUL, licencié en sciences économiques appliquées,

beruflich wohnhaft in L-2163 Luxemburg, 5, Avenue Monterey, eröffnet.

Der Vorsitzende bestellt zum Schriftführer und die Versammlung wählt zum Stimmenzähler Herr Christian DOSTERT,

Angestellter, beruflich wohnhaft in L-1466 Luxemburg, 12, rue Jean Engling.

Der Vorstand der Versammlung ist damit konstituiert und der Vorsitzende erklärt und ersucht den Notar folgendes

zu beurkunden:

A) Dass die Tagesordnung der Versammlung wie folgt lautet:

<i>Tagesordnung

1. Abänderung des zweiten Absatzes von Artikel 5 der Statuten;
2. Verschiedenes.
B) Dass die anwesenden oder vertretenden Gesellschafter, sowie die Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien, in einer

Anwesenheitsliste vermerkt werden; diese Anwesenheitsliste wird von den anwesenden Gesellschaftern, den Bevoll-
mächtigten der vertretenen Gesellschafter, den Mitgliedern des Vorstands der Versammlung und dem unterzeichneten
Notar unterzeichnet.

C) Dass die Vollmachten der vertretenen Gesellschafter, von den Mitgliedern des Vorstands der Versammlung und

dem unterzeichneten Notar „ne varietur“ unterzeichnet, dieser Urkunde beigebogen werden, um mit derselben einre-
gistriert zu werden.

D) Dass das gesamte Gesellschaftskapital anwesend oder vertreten ist und dass alle anwesenden oder vertretenen

Gesellschafter erklären, eine entsprechende Einberufung erhalten zu haben und dass sie vor Versammlungsdatum über
die Tagesordnung verfügen konnten.

Keine weiteren Einberufsmitteilungen waren erforderlich.
E) Dass diese Versammlung, die das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, ordnungsgemäß einberufen wurde und dass

rechtsgültige Beschlüsse über alle in der Tagesordnung angegebenen Themen gefasst werden können.

Alsdann hat die Versammlung, nach Beratung, einstimmig folgenden Beschluss gefasst:

<i>Beschluss

Die Versammlung beschließt den zweiten Absatz von Artikel 5 der Statuten, betreffend das Bestehen eines Aktien-

agiokontos, abzuändern und diesem fortan folgenden Wortlaut zu geben:

172075

L

U X E M B O U R G

„Zusätzlich zum Gesellschaftskapital kann ein Agiokonto eingerichtet werden, in welches der auf eine Aktie bezahlte

Ausgabeaufschlag eingestellt wird. Der Betrag auf dem genannten Agiokonto steht dem (den) Gesellschafter(n) zur freien
Verfügung.“

Da keine weiteren Punkte auf der Tagesordnung standen, hat der Vorsitzende darauf die Versammlung geschlossen.

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr 905,- EUR.

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar, welcher Englisch und Deutsch spricht und versteht, erklärt hiermit, dass die vorliegende

Urkunde  in  Englisch  verfasst  ist,  gefolgt  von  einer  deutschen  Fassung;  auf  Antrag  der  Komparenten  und  im  Fall  von
Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen Fassung, wird die englische Fassung maßgebend sein.

WORÜBER die vorliegende notarielle Urkunde in Luxemburg, an dem oben angegebenen Tag, erstellt wurde.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach Vor- und Zunamen,

Personenstand und Wohnort bekannt, haben die besagten Komparenten zusammen mit Uns dem Notar, gegenwärtige
Urkunde unterschrieben.

Signé: J-P. SCHAUL, C. DOSTERT, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 18 septembre 2014. LAC/2014/43361. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 22 octobre 2014.

Référence de publication: 2014168576/116.
(140191995) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2014.

MCT Berlin Zwei S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 5, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 114.385.

In the year two thousand and fourteen, on the twelfth day of the month of September;
Before the undersigned notary Carlo WERSANDT, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg);

Is held

an extraordinary general meeting of the shareholders (the “Meeting”) of the public limited company (“Aktiengesell-

schaft”) “MCT BERLIN ZWEI S.A.”, with registered office in L-2163 Luxembourg, 5, avenue Monterey, registered with
the Trade and Companies Register of Luxembourg, section B, under the number 114385, (hereafter the “Company”),
incorporated pursuant to a deed of the notary Henri HELLINCKX, then residing in Mersch (Grand Duchy of Luxembourg),
on February 3, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 951 of May 16, 2006,

and whose articles of association (the “Articles”) have been amended pursuant to a deed of the notary Jean-Joseph

WAGNER, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg), on September 25, 2009, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, number 2080 of October 22, 2009.

The Meeting is opened by Mr. Jean-Paul SCHAUL, licencié en sciences économiques appliquées, residing professionally

in L-2163 Luxembourg, 5, avenue Monterey (Grand Duchy of Luxembourg), being in the chair.

The Chairman appoints as secretary and the Meeting elects as scrutineer Mr. Christian DOSTERT, employee, residing

professionally in L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

The board of the Meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state the

following:

A) That the agenda of the Meeting is the following:

<i>Agenda

1. Amendment of the second paragraph of article 5 of the by-laws;
2. Miscellaneous.
B) That the shareholders present or represented, as well as the number of the shares held by them, are shown on an

attendance list; this attendance list is signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders, the mem-
bers of the board of the Meeting and the officiating notary.

C) That the proxies of the represented shareholders, signed “ne varietur” by the members of the board of the Meeting

and the officiating notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.

172076

L

U X E M B O U R G

D) That the whole corporate capital is present or represented at the present Meeting and that all the present or

represented shareholders declare having had due notice and got knowledge of the agenda prior to this Meeting.

No other convening notices were necessary.
E) That the present Meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deli-

berate on all the items on the agenda.

Then the Meeting, after deliberation, has taken unanimously the following resolution:

<i>Resolution

The Meeting resolves to amend the second paragraph of article 5 of the Articles, relating to the existence of a share

premium account, and to give it henceforth the following wording:

“In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account, into which any premium paid on any

share is transferred. The amount of said premium account is at the free disposal of the shareholder(s).”

There being no further business on the agenda, the Chairman thereupon has closed the Meeting.

<i>Expenses

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately 905.- EUR.

<i>Statement

The undersigned notary, who speaks and understands English and German, states herewith that the present deed is

worded in English followed by a German version; on request of the appearing persons and in case of divergences between
the English and the German version, the English version will be prevailing.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The deed having been read to the appearing persons, known to the officiating notary by their first and last name, civil

status and residence, the said appearing persons have signed together with Us the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Fassung des vorangegangenen Textes:

Im Jahre zweitausendvierzehn, am zwölften Tag des Monats September;
Vor dem unterzeichneten Notar Carlo WERSANDT, mit dem Amtssitz in Luxembourg (Großherzogtum Luxemburg);
Wird ein außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre (die „Versammlung“) der Aktiengesellschaft „MCT

BERLIN ZWEI S.A.“, mit Sitz in L-2163 Luxemburg, 5, Avenue Monterey, eingetragen beim Handels- und Gesellschafts-
register von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 114385, (hiernach die „Gesellschaft“), gegründet gemäß Urkunde
aufgenommen durch Notar Henri HELLINCKX, mit dem damaligen Amtssitz in Mersch (Großherzogtum Luxemburg),
am 3. Februar 2006, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 951 vom 16. Mai 2006,

und deren Statuten (die „Statuten“) sind abgeändert worden gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Jean-Joseph

WAGNER, mit dem Amtssitz in Sassenheim (Großherzogtum Luxemburg), am 25. September 2009, veröffentlicht im
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 2080 vom 22. Oktober 2009.

Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Herrn Jean-Paul SCHAUL, licencié en sciences économiques appliquées,

beruflich wohnhaft in L-2163 Luxemburg, 5, Avenue Monterey, eröffnet.

Der Vorsitzende bestellt zum Schriftführer und die Versammlung wählt zum Stimmenzähler Herr Christian DOSTERT,

Angestellter, beruflich wohnhaft in L-1466 Luxemburg, 12, rue Jean Engling.

Der Vorstand der Versammlung ist damit konstituiert und der Vorsitzende erklärt und ersucht den Notar folgendes

zu beurkunden:

A) Dass die Tagesordnung der Versammlung wie folgt lautet:

<i>Tagesordnung

1. Abänderung des zweiten Absatzes von Artikel 5 der Statuten;
2. Verschiedenes.
B) Dass die anwesenden oder vertretenden Gesellschafter, sowie die Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien, in einer

Anwesenheitsliste vermerkt werden; diese Anwesenheitsliste wird von den anwesenden Gesellschaftern, den Bevoll-
mächtigten der vertretenen Gesellschafter, den Mitgliedern des Vorstands der Versammlung und dem unterzeichneten
Notar unterzeichnet.

C) Dass die Vollmachten der vertretenen Gesellschafter, von den Mitgliedern des Vorstands der Versammlung und

dem unterzeichneten Notar „ne varietur“ unterzeichnet, dieser Urkunde beigebogen werden, um mit derselben einre-
gistriert zu werden.

D) Dass das gesamte Gesellschaftskapital anwesend oder vertreten ist und dass alle anwesenden oder vertretenen

Gesellschafter erklären, eine entsprechende Einberufung erhalten zu haben und dass sie vor Versammlungsdatum über
die Tagesordnung verfügen konnten.

172077

L

U X E M B O U R G

Keine weiteren Einberufsmitteilungen waren erforderlich.
E) Dass diese Versammlung, die das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, ordnungsgemäß einberufen wurde und dass

rechtsgültige Beschlüsse über alle in der Tagesordnung angegebenen Themen gefasst werden können.

Alsdann hat die Versammlung, nach Beratung, einstimmig folgenden Beschluss gefasst:

<i>Beschluss

Die Versammlung beschließt den zweiten Absatz von Artikel 5 der Statuten, betreffend das Bestehen eines Aktien-

agiokontos, abzuändern und diesem fortan folgenden Wortlaut zu geben:

„Zusätzlich zum Gesellschaftskapital kann ein Agiokonto eingerichtet werden, in welches der auf eine Aktie bezahlte

Ausgabeaufschlag eingestellt wird. Der Betrag auf dem genannten Agiokonto steht dem (den) Gesellschafter(n) zur freien
Verfügung.“

Da keine weiteren Punkte auf der Tagesordnung standen, hat der Vorsitzende darauf die Versammlung geschlossen.

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr 905,- EUR.

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar, welcher Englisch und Deutsch spricht und versteht, erklärt hiermit, dass die vorliegende

Urkunde  in  Englisch  verfasst  ist,  gefolgt  von  einer  deutschen  Fassung;  auf  Antrag  der  Komparenten  und  im  Fall  von
Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen Fassung, wird die englische Fassung maßgebend sein.

WORÜBER die vorliegende notarielle Urkunde in Luxemburg, an dem oben angegebenen Tag, erstellt wurde.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach Vor- und Zunamen,

Personenstand und Wohnort bekannt, haben die besagten Komparenten zusammen mit Uns dem Notar, gegenwärtige
Urkunde unterschrieben.

Signé: J-P. SCHAUL, C. DOSTERT, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 18 septembre 2014. LAC/2014/43360. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 22 octobre 2014.

Référence de publication: 2014168577/114.
(140191988) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2014.

P.M.E Invest S.A.-SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 37.735.

L’an deux mille quatorze, le treize octobre.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est réunie

l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «P.M.E. INVEST S.A.-SPF», établie et ayant

son siège social au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
et à Luxembourg, section B sous le numéro 37735, constitué suivant acte notarié en date du 25 juillet 1991, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 45 du 7 février 1991. Les statuts ont été modifiés en dernier
lieu suivant acte notarié en date du 09 octobre 2014, non encore publié au Mémorial C.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Alain GEURTS, employé privé, avec adresse professionnelle

à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Marc BESCH, employé privé, avec adresse professionnelle à Lu-

xembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Frédérique MIGNON, employée privée, avec adresse professionnelle

à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent
se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

172078

L

U X E M B O U R G

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées «ne varietur» par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Modification du statut fiscal de la Société qui n’aura plus désormais le statut d'une société de gestion de patrimoine

familial ("SPF") défini par la loi du 11 mai 2007.

2. Modification de l’article premier des statuts de la société qui se lira dorénavant comme suit:
«Il existe une société anonyme sous la dénomination de «P.M.E. INVEST S.A.».
3. Modification de l’article deux des statuts de la société comme suit:
«La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations,

sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que l’administration, la
gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut également développer, acquérir, céder et exploiter des marques, brevets et tous autres droits similaires

ou équivalents, à Luxembourg et à l’étranger.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un

portefeuille se composant de tous titres de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de
toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière,
tous titres, les réaliser par voie de vente,de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires, accorder
à d’autres sociétés ou entreprises dans lesquelles la société détient un participation ou qui font partie du même groupe
de sociétés que la société, tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières, qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.»

4. Modification de l’article onze des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur appli-

cation partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.»

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C)  Que  l’intégralité  du  capital  social  étant  représentée,  il  a  pu  être  fait  abstraction  des  convocations  d’usage,  les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de modifier le statut fiscal de la Société qui n’aura plus désormais le statut

d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF") défini par la loi du 11 mai 2007.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de modifier le premier alinéa de l’article premier des statuts de la société

qui se lira dorénavant comme suit:

Art. 1 

er

 . (premier alinéa).  «Il existe une société anonyme sous la dénomination de «P.M.E. INVEST S.A.».»

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de modifier l’article deux des statuts de la société comme suit:

Art. 2.  «La  société  a  pour  objet  toutes  les  opérations  se  rapportant  directement  ou  indirectement  à  la  prise  de

participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que l’admi-
nistration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut également développer, acquérir, céder et exploiter des marques, brevets et tous autres droits similaires

ou équivalents, à Luxembourg et à l’étranger.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un

portefeuille se composant de tous titres de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de
toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière,
tous titres, les réaliser par voie de vente,de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires, accorder
à d’autres sociétés ou entreprises dans lesquelles la société détient un participation ou qui font partie du même groupe
de sociétés que la société, tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières, qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.»

172079

L

U X E M B O U R G

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de modifier l’article onze des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 11. «La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur

application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire

instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: A. GEURTS, M. BESCH, F. MIGNON, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 16 octobre 2014. Relation: EAC/2014/14001. Reçu soixante-quinze Euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur ff.

 (signé): Monique HALSDORF.

Référence de publication: 2014168007/93.
(140191453) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2014.

Royal Media Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 74, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 75.631.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30/10/2014.

G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg

Référence de publication: 2014168672/12.
(140192188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2014.

Saffron Lux HoldCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 12.000,00.

Siège social: L-1748 Findel, 7, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 184.624.

EXTRAIT

La Société a été informée que le nom d'une gérante de catégorie B de la Société, Madame Dalia Ziukaite, a été changé

pour Dalia Bleyer.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 novembre 2014.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014170046/15.
(140194089) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2014.

Station FRANCO S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6686 Mertert, 55, route de Wasserbillig.

R.C.S. Luxembourg B 20.015.

<i>Extrait des décisions prises

1) l'Assemblée accepte la démission de Mme Thiel Marie-Paule comme gérante avec effet avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société

Référence de publication: 2014170058/12.
(140194147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2014.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

172080


Document Outline

26 Investments S.A.

4 Pat

6922767 Holding Sàrl

Actic International S.à r.l.

Acti-Medic S.A.

Addyx

Adis S.à.r.l.

Adis S.à.r.l.

AI Alu (Luxembourg) Holding S.à r.l.

Aigle Aviation S.à r.l.

Aigle Aviation S.à r.l. &amp; Cie, SECS

Alphabeta 3 International S.à r.l.

Altice France S.A.

Aon Holdings Luxembourg S.à r.l.

ArcelorMittal Energy S.C.A.

Avenue Foch Holdings S.à r.l.

Avenue Foch S.à r.l.

Aviva Investor EBC S.à r.l.

Aviva Investors Polish Retail S.à r.l.

ITELCO Luxembourg

JOY OF DURABLE VALUES en abrégé JDV SARL

K Beta S.A.

K&amp;D Development

K-Group Engineering S.A.

Le Fond et la Forme S.à r.l.

Lungo Mare S.A.

MCT Berlin Vier S.A.

MCT Berlin Zwei S.A.

Phoenix III Mixed R

Phoenix III Mixed U

Phoenix II Mixed L

P.M.E Invest S.A.-SPF

Project Blue S.à r.l.

Rita's Barber Shop Sàrl

Rome Intermediate Holdings S. à r.l.

Royal Media Group S.à r.l.

RP Kosmoscenter S.à r.l.

RP Medicentre S.à r.l.

RP Ruegen S.à r.l.

RP Schwedt S.à r.l.

RP Waldstadt S.à r.l.

Saffron Lux HoldCo S.à r.l.

Selena Luxco S.à r.l.

Shinkin Investments S.à r.l.

Station FRANCO S.à r.l.

Synplants Marketing SA

Zentralux S.A.