This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 3567
26 novembre 2014
SOMMAIRE
3V Participations Luxembourg S.A. . . . . . .
171181
Accipiter Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
171181
Apollinaire S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
171173
Aqua Infrastructure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
171174
Arcelormittal Foundation . . . . . . . . . . . . . . .
171214
Aures Services S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
171173
Azimut Europe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
171183
Azimut Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
171183
Baby Company S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
171171
Barika S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
171173
Blake S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
171183
Catalyst Buyout I S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
171174
CITRA IMMOBILIERE SARL . . . . . . . . . . . .
171170
Cogalux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
171176
Conselio S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
171174
Dahm Gaslog Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
171184
Dakota Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
171175
Damrock S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
171184
Daripod Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
171199
Dentsply Benelux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
171170
Dentsply S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
171183
Dictame II S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
171184
ELDIJK Mineral Oil Transport Sàrl . . . . . .
171213
Forêt Vierge S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
171185
Gestron Services (Luxembourg) S.A. . . . .
171176
Giveall2Charity, Luxembourg Branch . . . .
171175
Hellas Telecommunications (Luxem-
bourg) II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
171175
HSH Investment Holdings FSO S.à r.l. . . .
171184
Melody S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
171185
Norden S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
171185
oneOone communication S.A. . . . . . . . . . .
171181
Orbit Fund Management S.à r.l. . . . . . . . . .
171186
PCM Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
171187
Pfaudler Midco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
171187
Philippe Schmit architects . . . . . . . . . . . . . .
171186
Red Blue (France) Properties S.à r.l. . . . . .
171187
Regent Acquisitions S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
171176
Silver Sea Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
171178
Thann International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
171179
The Swatch Group Re (Luxembourg) S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
171179
TH Leo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
171179
Triton Masterluxco 3 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
171179
Umbrellastream S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
171180
Vania & Diana S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
171182
Wullmaart-Pommerlach S.A. . . . . . . . . . . .
171180
Xilco Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
171180
171169
L
U X E M B O U R G
Dentsply Benelux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 170.952.
<i>Extrait des décisions prises par les associées et le conseil de gérance en date du 07 octobre 2014i>
1. M. Hugo FROMENT démissionné de son mandat de gérant de catégorie B.
2. Mlle Ingrid CERNICCHI, administrateur de sociétés, née à Metz (France), le 18 Mai 1983, demeurant profession-
nellement à L-2453 Luxembourg 6, rue Eugène Ruppert, a été nommée comme gérant de catégorie B pour une durée
indéterminée.
3. Le siège social a été transféré de L-1331 -Luxembourg, 65 bld Grande Duchesse Charlotte à 2453 Lux, 6, rue Eugène
Ruppert R.C.S. Luxembourg B166580.
Veuillez noter que les adresses professionnelles de Messieurs Andrew O'SHEA et Douwe TERPSTRA gérants de
catégorie B, se situent désormais au L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
Luxembourg, le 07 octobre 2014.
Pour extrait et avis sincères et conformes
<i>Pour Dentsply Benelux S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2014168335/20.
(140192490) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2014.
CITRA IMMOBILIERE SARL, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3321 Berchem, 9A, rue du Chemin de Fer.
R.C.S. Luxembourg B 191.390.
STATUTS
L'an deux mille quatorze, le trois octobre.
Pardevant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
- BMS Luxembourg S.A.,une société anonyme,constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son
siège social au 27, avenue de la Gare, L-9540 Wiltz, Grand-Duché du Luxembourg, ayant un capital de trente et un mille
euros (EUR 31.000,-), immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B186.509.
représentée par son administrateur unique, Joao Claudio ANTUNES VALENTE DE MOURA, employé, demeurant à
L-3877 Schifflange, 47, rue du Stade, habilité à engager la société par sa seule signature, agissant sur base de l’artice 7 des
statuts de la société,
lui-même ici représenté par Boubakeur BELARIBI, gérant d'entreprise, demeurant à L-3321 Berchem, 9A, rue du
Chemin de Fer, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 1
er
octobre 2014.
Laquelle procuration, après avoir été signée ''ne varietur'' par le mandataire de la comparante et le notaire instru-
mentant, restera annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Le comparant a requis le notaire de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'il
déclare constituer.
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de "CITRA IMMOBILIERE SARL".
Art. 2. Le siège de la société est établi dans la commune de Berchem.
Art. 3. La société a pour objet l’acquisition et la vente de biens immobiliers, soit au Grand-Duché de Luxembourg soit
à l’étranger ainsi que toutes les opérations liées à des biens immobiliers, comprenant la prise de participations directes
ou indirectes dans des sociétés au Luxembourg ou à l’étranger.
Elle pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières qui se ratta-
chent directement ou indirectement, en tout ou partie, à son objet social.
Art. 4. La durée de la société est indéterminée.
Art. 5. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500,-€), représenté par CENT (100) parts
sociales de CENT VINGT-CINQ EUROS (125,- €) chacune.
Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
171170
L
U X E M B O U R G
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que conformément aux dispositions
de l’article 189 du texte coordonné de la loi du 10 août 1915 et des lois modificatives.
Art. 7. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée de
leur mandat, leur rémunération (s'il en est) et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication
de motif.
Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, les parties s'en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2014.
<i>Souscription et libérationi>
Les parts sociales ont été souscrites comme suit:
1) BMS Luxembourg SA, cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Total: Cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces.
<i>Fraisi>
Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approxi-
mativement à huit cent cinquante euros (850,-EUR).
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Ensuite, l’associée unique,préqualifiée et représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
- L'adresse de la société est fixée à L-3321 Berchem, 9A, rue du Chemin de Fer.
- Le nombre des gérants est fixé à un (1).
- Est nommé gérant, pour une durée illimitée:
Monsieur Boubakeur BELARIBI, gérant d'entreprise, demeurant à L-3321 Berchem, 9A, rue du Chemin de Fer.
La société est engagée par la signature individuelle du gérant.
Le notaire instrumentant a rendu attentif le comparant au fait qu’avant toute activité commerciale de la société pré-
sentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénoms usuels, état et
demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: BELARIBI, ARRENSDORFF.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 10 octobre 2014. Relation: LAC / 2014 / 47400. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.
Luxembourg, le 30 octobre 2014.
Référence de publication: 2014168317/71.
(140192428) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2014.
Baby Company S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9964 Huldange, 2, rue de Stavelot.
R.C.S. Luxembourg B 99.507.
L’an deux mille quatorze, le vingt et un octobre.
Par-devant Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
S’est réunie
l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «BABY COMPANY S.A.», ayant son siège
social à L-9638 Pommerloch, 19, route de Bastogne, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 99507, constituée sous la forme d’une société à responsabilité limitée en date du 6 décembre 1990
suivant acte reçu par Maître Paul DECKER, notaire alors de résidence à Echternach, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations numéro 181 du 15 avril 1991, dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu en date du 8
171171
L
U X E M B O U R G
février 2013 suivant acte reçu par le notaire soussigné, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro
824 du 8 avril 2013.
L'assemblée est présidée par Madame Monique Drauth, salariée, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Alida Muhovic, salariée, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg.
L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Mustafa Nezar, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions
qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l’assemblée, les actionnaires présents,
les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants, resteront
également annexées au présent acte.
II.- Qu’il appert de cette liste de présence que les 100 (cent) actions représentant l’intégralité du capital social, sont
présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider vala-
blement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment
convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Transfert du siège social de la société de L-9638 Pommerloch, 19, route de Bastogne vers l’adresse suivante: L-9964
Huldange, 2, rue de Stavelot,
2. Modification subséquente du deuxième et troisième alinéa de l’article 1
er
des statuts de la société.
3. Modification de la date de l’assemblée générale annuelle de la Société au dernier lundi du mois de juin de chaque
année à 10:00 heures;
4. Modification subséquente du premier paragraphe de l’article 10 des statuts.
5. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée cette dernière a pris à l’unanimité des voix la résolution suivante:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de transférer le siège social de la société de L-9638 Pommerloch, 19, route de Bastogne vers
l’adresse suivante: L-9964 Huldange, 2, rue de Stavelot,
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide de modifier par conséquent le deuxième et troisième alinéa de l’article 1
er
des statuts de la société
pour lui donner la teneur suivante:
Art. 1
er
. (alinéa 2 et 3). «Le siège social est fixé dans la commune de Troisvierges.
Le siège social peut être transféré à tout autre endroit de la même commune par une décision du conseil d’adminis-
tration, et à tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg par une décision des actionnaire(s) délibérant comme
en matière de modification de statuts.»
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide de changer la date de l’assemblée générale annuelle statutaire de la société pour qu’elle se tienne
désormais le dernier lundi du mois de juin de chaque année à 10:00 heures.
<i>Quatrième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l’article 10 des
statuts pour lui donner la teneur suivante:
Art. 10. (premier paragraphe). «L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social
de la société, ou à tout autre endroit, tel qu'il sera précisé dans la convocation à ladite assemblée, le dernier lundi du
mois de juin à 10:00 heures.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée aux comparants par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec
le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: Drauth, Muhovic, Nezar, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 22 octobre 2014. Relation: LAC/2014/49357. Reçu soixante-quinze euros.
(75,00 €).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène Thill.
171172
L
U X E M B O U R G
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Luxembourg, le 30 octobre 2014.
Référence de publication: 2014168267/70.
(140192221) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2014.
Aures Services S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 4-6, avenue Victor Hugo.
R.C.S. Luxembourg B 75.399.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014168258/9.
(140192032) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2014.
Apollinaire S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 16A, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 152.882.
<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 28 octobre 2014i>
RÉVOCATION DE L'ADMINISTRATEUR UNIQUE ACTUELLEMENT NOMME
L'assemblée générale décide de révoquer avec effet immédiat, l'actuel administrateur unique, Monsieur Dominique
DELABY.
NOMINATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR UNIQUE EN REMPLACEMENT DE L'ADMINISTRATEUR RÉ-
VOQUE
L'assemblée générale décide de nommer avec effet immédiat aux fonctions d'administrateur unique, pour une durée
prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2019:
- Gérard BEN KHALIFA
Né le 08/01/1955 à Tunis
Demeurant à F-75017 Paris, 194 rue de Courcelles
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014168248/20.
(140191997) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2014.
Barika S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 189.260.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 30 octobre 2014i>
Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 30 octobre 2014 que:
L'Assemblée Générale décide de transférer le siège social de la société du 3, rue Jean Piret L-2350 Luxembourg au 50,
rue Charles Martel L-2134 Luxembourg.
L'Assemblée Générale accepte la démission, avec effet immédiat, des gérants suivants:
- Monsieur Marc GIORGETTI, gérant domicilié professionnellement au 3, rue Jean Piret à L-2350 Luxembourg.
- Monsieur Jacques FUNK, gérant, domicilié professionnellement au 79, rue des Champs à L-8053 Luxembourg.
L'Assemblée Générale décide de procéder à la nomination d'un nouveau gérant, à savoir:
- Monsieur Claude ZIMMER, gérant, né né le 18 juillet 1956 à Luxembourg (Luxembourg), domicilié professionnelle-
ment au 50 rue Charles Martel L-2134 Luxembourg.
Extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2014168260/20.
(140192721) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2014.
171173
L
U X E M B O U R G
Aqua Infrastructure, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 176.029.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale de la Société tenue en date du 27 octobre 2014i>
En date du 27 octobre 2014, l'assemblée générale de la Société a pris la résolution de nommer les personnes suivantes
en tant que nouveaux administrateurs B de la Société avec effet immédiat et ce jusqu'à la date à laquelle l'assemblée
générale des actionnaires ou l'actionnaire unique, selon le cas, décide de l'approbation des comptes de la Société pour
l'exercice social 2018 ou à toute date antérieure déterminée par l'assemblée générale des actionnaires ou par l'actionnaire
unique, selon le cas:
- Monsieur Alain PLANCHOT, né le 22 février 1953 à Paris, France, résidant à l'adresse suivante: 84, rue des Tenne-
rolles, 92210 Saint-Cloud, France;
- Monsieur Alain GAJAN, né le 8 juin 1945 à Casablanca, Maroc, résidant à l'adresse suivante: 7, rue du Mont Valérien,
92210 Saint-Cloud, France.
En conséquence, le conseil d'administration de la Société est désormais composé comme suit:
- Lionel LE MAUX, administrateur A
- Yves WAGNER, administrateur B
- Laurent SMOLEN, administrateur B
- Alain PLANCHOT, administrateur B
- Alain GAJAN, administrateur B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 octobre 2014.
AQUA INFRASTRUCTURE
Signature
Référence de publication: 2014168249/27.
(140192083) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2014.
Catalyst Buyout I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 119.578.
Les comptes annuels au 30 juin 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 octobre 2014.
Jack Mudde / Jorge Perez Lozano
<i>Gérant / Géranti>
Référence de publication: 2014168292/12.
(140192328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2014.
Conselio S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4384 Ehlerange, Z.A.R.E. Ouest.
R.C.S. Luxembourg B 146.985.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30/10/2014.
G.T. Experts comptables S.À.R.L.
Luxembourg
Référence de publication: 2014168297/12.
(140192485) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2014.
171174
L
U X E M B O U R G
Dakota Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 116.920.
Le bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 octobre 2014.
<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
i>Signature
Référence de publication: 2014168346/12.
(140192181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2014.
Hellas Telecommunications (Luxembourg) II, Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 93.039.
EXTRAIT
Il résulte d'une décision (Order) de la High Court of Justice de Londres, rendue en date du 7 mai 2014, que Monsieur
Simon James BONNEY a été délié de ses fonctions de liquidateur, et que Monsieur Bruce Alexander MACKAY, avec
adresse professionnelle auprès de BAKER TILLY RESTRUCTURING AND RECOVERY LLP, 25 Farringdon Street, LON-
DRES (ROYAUME-UNI) EC4A 4AB, a été nommé en son remplacement, le tout avec effet à la même date du 7 mai 2014.
Il en résulte que les deux liquidateurs de la société sont dorénavant:
Monsieur Andrew Lawrence HOSKING, né le 15 juin 1966, avec adresse professionnelle à 10 Fitzroy Square, LON-
DRES (ROYAUME-UNI) W1T 5HP (p.a. QUANTUMA LLP),
et
Monsieur Bruce Alexander MACKAY, né le 28 mai 1958, demeurant professionnellement à 25, Farringdon Street,
LONDRES (ROYAUME-UNI) EC4A 4AB (p.a. BAKER TILLY RESTRUCTURING AND RECOVERY LLP).
Dans le cadre de la liquidation, chacun des liquidateurs a le pouvoir d'agir sous sa signature individuelle.
La présente publication a lieu par application des dispositions de l'article 21 du règlement européen 1346/2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 octobre 2014.
<i>Pour HELLAS TELECOMMUNICATIONS (Luxembourg) Il SCA en liquidation judiciaire
i>Par délégation spéciale
Me Claude GEIBEN
Référence de publication: 2014168432/25.
(140192256) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2014.
Giveall2Charity, Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.
Adresse de la succursale: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 175.555.
Les comptes annuels de la société mère Giveall2Charity au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour la succursale
<i>Le Géranti>
Référence de publication: 2014168417/12.
(140192028) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2014.
171175
L
U X E M B O U R G
Gestron Services (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 49.836.
EXTRAIT
L'Assemblée Générale Extraordinaire du 10 octobre 2014 décide de nommer Monsieur Laurent Barnich, demeurant
professionnellement à L-1720 Luxembourg, 6 rue Heine, en tant administrateur de la société avec effet immédiat jusqu'à
l'Assemblée Générale Annuelle de 2017.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Gestron Services (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2014168414/13.
(140192014) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2014.
Cogalux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8008 Strassen, 130, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 108.335.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
L-8008 Strassen, le 30 octobre 2014.
<i>Le Conseil d'Administrationi>
Référence de publication: 2014168322/11.
(140192538) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2014.
Regent Acquisitions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 170.469.
In the year two thousand and fourteen, on the twenty second day of the month of October.
Before Maître Edouard DELOSCH, notary residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg,
was held
an extraordinary general meeting (the “Meeting”) of shareholders of Regent Acquisitions S.à r.l. (the “Company”), a
société à responsabilité limitée, established under the laws of Luxembourg, having its registered office at L-1855 Luxem-
bourg, 46A, Avenue J.F. Kennedy and registered with the Register of Trade and Companies of Luxembourg under number
B 170.469, incorporated by deed of Maître Francis KESSELER, notary residing in Esch-sur-Alzette, on 13 July 2012, pu-
blished in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the “Mémorial”) of 30 August 2012, under number 2152
(The «Company»).
The meeting was declared open at 10.00 a.m., under the chair of Ms.Nathalie CHEVALIER, private employee, with
professional address in Luxembourg, in the chair, who appointed as secretary Ms Tina STANKO, private employee, with
professional address in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Ms. Tina STANKO, private employee, with professional address in Luxembourg.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to record
the following:
I. The Sole Shareholder represented and the number of shares held by him are shown on the attendance list, signed
by the chairman, the secretary and scrutineer and the undersigned notary.
This list and the proxy signed «ne varietur» will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.
II. The Sole Shareholder represented has declared having had sufficient prior knowledge of the agenda of the Meeting
and waived his rights to any prior convening notice thereof so that the meeting can validly decide on all items on the
agenda.
III. It appears from the attendance list that all the twelve thousand five hundred (12,500) Shares in issue are represented
at the Meeting so that the Meeting is duly constituted, is quorate and may validly deliberate on the agenda set out below:
<i>Agendai>
1. To dissolve the Company and to put the Company into liquidation.
2. To appoint as liquidator Fides (Luxembourg) S.A. and determination of the powers of the liquidator.
3. Miscellaneous
171176
L
U X E M B O U R G
After the foregoing has been approved the Sole Shareholder took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Meeting resolved to dissolve and to put the Company into liquidation.
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolved to appoint Fides (Luxembourg) S.A., a société anonyme, with registered office at L-1855 Lu-
xembourg, 46a, avenue J.F. Kennedy, and registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg under number
B 41.469, as liquidator.
The fullest powers, particularly those set forth in articles 144 and following of the law of 10 August 1915 on commercial
companies (as amended), are granted to the liquidator by the Meeting.
The Meeting resolved to authorise the liquidator in advance to execute the acts and enter into the deeds set forth in
article 145 of the same law without any special authorisation from the Meeting if such authorisation is required by law.
The Meeting resolved to dispense the liquidator from drawing up an inventory and the liquidator may refer to the
books of the Company.
The liquidator may delegate, under his responsibility, all or part of his powers to one or more proxies with respect
to specific acts or deeds.
The Meeting resolved that the liquidator may bind the Company under his sole signature.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed
are estimated at one thousand two hundred euro (EUR 1,200.-).
There being no further business on the agenda the meeting was closed.
The undersigned notary who understands and speaks English acknowledges that, at the request of the parties hereto,
this deed is drafted in English, followed by a French translation; at the request of the same parties, in case of inconsistencies
between the English and the French version, the English version shall prevail.
Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the
beginning of this document.
The document having been read to the Members of the Bureau, who are known to the undersigned notary by their
surname, first name, civil status and residence, such persons signed together with the undersigned notary, this original
deed.
Suit la traduction française de ce qui précède
L'an deux mille quatorze, le vingt-deuxième jour du mois d’octobre.
Par-devant Maître DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg,
s’est tenue
une assemblée générale extraordinaire (l’«Assemblée») de Regent Acquisitions S.à r.l. (la "Société"), une société à
responsabilité limitée ayant son siège social au L-1855 Luxembourg, 46A, Avenue J.F. Kennedy et inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 170.469, constituée suivant acte de Maître Francis KES-
SELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette en date du 13 juillet 2012, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations (le «Mémorial»), du 30 août 2012, sous le numéro 2152.
L'assemblée a été déclarée ouverte à 10.00 heures, sous la présidence de Madame Nathalie CHEVALIER, employée
privée, domiciliée professionnellement à Luxembourg, qui a désigné comme secrétaire Madame Tina STANKO, employée
privée, domiciliée professionnellement à Luxembourg.
L'assemblée a choisi comme scrutateur Madame Tina STANKO, employée privée, domiciliée professionnellement à
Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le président a exposé et prié le notaire soussigné d'acter ce qui suit:
I. L’Associé Unique représenté ainsi que le nombre d’actions sont renseignés sur une liste de présence signée par le
président, le secrétaire et scrutateur et le notaire soussigné.
La procuration signée «ne varietur» par la partie comparante restera annexée au présent document pour être soumises
aux formalités de l’enregistrement.
II. L’Associé Unique représenté comme dit ci-dessus, a déclaré avoir été préalablement suffisamment informé de l’ordre
du jour de l’assemble générale et a renoncé à ses droits à un avis de convocation y relatif, de sorte que l’assemblée
générale peut se prononcer valablement sur tous les points inscrits à l’ordre du jour.
III. Il résulte de la liste de présence que toutes les douze mille cinq cents parts sociales sont représentées et que la
présente assemblée générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour fixé ci-
dessous:
1. Dissolution de la Société et mise en liquidation de la Société.
171177
L
U X E M B O U R G
2. Nomination de Fides (Luxembourg) S.A. comme liquidateur et fixation des pouvoirs du liquidateur.
3. Divers.
Ayant approuvé ce qui précède, l’Assemblée a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée a décidé de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation.
<i>Seconde résolutioni>
L’Assemblée a décidé de nommer Fides (Luxembourg) S.A., société anonyme avec siège social à L-1855 Luxembourg,
46a, avenue J.F. Kennedy, et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 41.469, en tant que liquidateur.
L’Assemblée a décidé de conférer au liquidateur les pouvoirs les plus étendus, spécialement ceux prévus aux articles
144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (telle que modifiée).
L’Assemblée a décidé d’autoriser par avance le liquidateur à signer les actes et conclure les contrats prévus à l’article
145 de la même loi sans devoir recourir à l’autorisation spéciale de l’Assemblée dans le cas où celle-ci est requise par la
loi.
L’Assemblée a décidé de dispenser le liquidateur de dresser un inventaire et le liquidateur peut se référer aux écritures
de la Société.
Le liquidateur peut déléguer, sous sa responsabilité, tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires pour
des actes ou contrats spécifiques.
L’Assemblée a décidé que le liquidateur pourra engager la Société sous sa seule signature.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués
à mille deux cents euros (EUR 1.200,-).
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, l’Assemblée a été clôturée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate qu’à la demande des parties comparantes, le présent a
été rédigé en langue anglaise, suivi d’une traduction française; à la demande des mêmes parties comparantes, la version
anglaise fera foi en cas de divergences entre les textes français et anglais.
Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux Membres du Bureau, connus du notaire soussigné par leurs
nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire soussigné, le présent acte.
Signé: N. CHEVALIER, T. STANKO, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 23 octobre 2014. Relation: DIE/2014/13510. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.
<i>Le Receveuri> (signé) pd: RECKEN.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Diekirch, le 29 octobre 2014.
Référence de publication: 2014168035/122.
(140191371) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2014.
Silver Sea Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 155.153.
I. Lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 19 septembre 2014, les actionnaires ont pris les décisions
suivantes:
1. Nomination de Matthew Rosenberg, avec adresse professionnelle au 29, Great Guildford Street, SE1 0ES Londres,
Royaume-Uni, au mandat d'administrateur A, avec effet au 7 octobre 2014 et pour une période venant à échéance lors
de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2019 et
qui se tiendra en 2020
2. Acceptation de la démission de Paul Justin Humphreys, avec adresse au 21, Great Winchester Street, EC2N 2JA
Londres, Royaume-Uni de son mandat d'administrateur A, avec effet au 7 octobre 2014;
II. L'adresse de l'administrateur A Robert Patrick Moores a changé et est désormais au 95, Wigmore Street, W1U
1FB, Londres, Royaume-Uni.
171178
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 octobre 2014.
Référence de publication: 2014168061/19.
(140191539) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2014.
TH Leo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 75.000,00.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 182.313.
EXTRAIT
Il résulte d'un contrat de cession signé le 15 octobre 2014 que la société THREE HILLS, associé unique de la Société,
a transféré cinq mille six cent vingt-cinq (5.625) parts sociales qu'elle détenait dans le capital social de la Société à Three
Hills I S.à r.l., une société ayant son siège social au 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B188993.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 octobre 2014.
Référence de publication: 2014168134/15.
(140191445) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2014.
Thann International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 183.383.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 9 octobre 2014i>
<i>Résolution:i>
Le Conseil d'Administration accepte la démission de Monsieur Winandy et décide de nommer à partir de ce jour
Monsieur Koen Lozie, 61, Grand-Rue, L-8510 Redange-sur-Attert en tant qu'Administrateur B.
Pour copie conforme
FIDUPAR
Signature
<i>Domiciliatairei>
Référence de publication: 2014168136/15.
(140191448) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2014.
The Swatch Group Re (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5835 Alzingen, 10, rue Hondsbreck.
R.C.S. Luxembourg B 108.652.
Die koordinierte Satzung vom 15/10/2014 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 28/10/2014.
Me Cosita Delvaux
<i>Notari>
Référence de publication: 2014168138/12.
(140191714) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2014.
Triton Masterluxco 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 143.926.
Les statuts coordonnés au 9 octobre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
171179
L
U X E M B O U R G
Marc Loesch
<i>Notairei>
Référence de publication: 2014168148/11.
(140191774) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2014.
Umbrellastream S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 100.000,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 138.245.
Veuillez prendre note du changement de nom du gérant suivant:
Madame Joanna Alwen HARKUS est désormais Joanna Alwen HARKUS MADGE, ayant pour adresse professionnelle
12, Charles II Street, troisième étage, Londres SW1Y 4QU, Royaume-Uni.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Umbrellastream S.à r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
Signatures
<i>Gérant Ai>
Référence de publication: 2014168153/16.
(140191616) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2014.
Wullmaart-Pommerlach S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9638 Pommerloch, 26, route de Bastogne.
R.C.S. Luxembourg B 96.591.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 21 août 2014 que:
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée générale décide de
les renouveler. Leurs mandats viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
de l'exercice 2016.
Le conseil d'administration se compose comme suit:
Monsieur Erny Schmitz, L-9964 Huldange, 2, rue de Stavelot, président du conseil d'administration, administrateur;
Madame Annette Knauf, L-9964 Huldange, 2, rue de Stavelot, administrateur;
Monsieur Justin Dostert, L-5969 Itzig, 93, rue de la Libération, administrateur.
<i>Commissaire aux comptesi>
Madame Liliane Theissen, B-4790 Burg-Reuland, Dürler 1
Pommerlach, le 21 août 2014.
Pour extrait conforme
WULLMAART-POMMERLACH SA
Référence de publication: 2014168181/21.
(140191936) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2014.
Xilco Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: DKK 5.400.000,00.
Siège social: L-1748 Findel, 7, rue Lou Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 147.146.
EXTRAIT
La Société a été informée que le nom d'un administrateur de la Société, Madame Dalia Ziukaite, a été changé pour
Dalia Bleyer.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
171180
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 29 octobre 2014.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2014168183/15.
(140191925) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2014.
3V Participations Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 67.800.
L'assemblée générale ordinaire tenue en date du 28 février 2014 a ratifié la décision prise par le Conseil d'Adminis-
tration du 24 juin 2013 de coopter Monsieur Cédric JAUQUET au poste d'administrateur de catégorie A, en remplace-
ment de Monsieur Yves BIEWER, démissionnaire. Le mandat de l'Administrateur définitivement élu s'achèvera lors à
l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2016.
Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 28 février 2014, Madame Magali MICHELETTI, résidant profession-
nellement au 42, Rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, a été nommée administrateur de catégorie A en remplacement
de Monsieur Cédric JAUQUET, administrateur démissionnaire. Le mandat de l'Administrateur définitivement élu s'achè-
vera à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2016.
Luxembourg, le 28 octobre 2014.
<i>Pour: 3V PARTICIPATIONS LUXEMBOURG S.A.
i>Société Anonyme
Experta Luxembourg
Société Anonyme
Référence de publication: 2014168189/20.
(140191843) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2014.
oneOone communication S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9999 Wemperhardt, 4, Op der Haart.
R.C.S. Luxembourg B 107.481.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Wiltz, le 30 octobre 2014.
<i>Pour la société
i>Joëlle SCHWACHTGEN
<i>Le notairei>
Référence de publication: 2014168211/13.
(140192623) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2014.
Accipiter Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 27.000,00.
Siège social: L-1728 Luxembourg, 7, rue du Marché-aux-herbes.
R.C.S. Luxembourg B 189.742.
EXTRAIT
Il résulte d'une cession de parts intervenue en date du 29 août 2014 que l'actionnaire de la Société, CK Capital Limited,
une limited liability company des Iles Cayman, ayant son siège social à Ugland House, South Church Street, George Town,
Grand Cayman KY1-1104, immatriculée auprès du registre des Iles Cayman sous le numéro MC-289224, a cédé l'inté-
gralité des 27.000 (vingt-sept mille) parts sociales de la Société qu'elle détenait à la société CK Capital (Hong Kong)
Limited, une limited liability company de Hong Kong, ayant son siège social à 7
th
Floor, Cheung Kong Center, 2 Queen's
Road Central, Hong Kong, immatriculée auprès du registre des sociétés de Hong Kong sous le numéro 2138074.
La société CK Capital (Hong Kong) Limited détient donc maintenant l'intégralité des parts sociales de la Société, soit
27.000 (vingt-sept mille) parts sociales ayant une valeur nominale de USD 1 (un dollar des Etats-Unis d'Amérique) chacune.
171181
L
U X E M B O U R G
Pour extrait sincère et conforme
Accipiter Finance S.àr.l.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2014168218/21.
(140192034) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2014.
Vania & Diana S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4320 Esch-sur-Alzette, 10, rue du Dix Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 174.672.
DISSOLUTION
L’an deux mille quatorze, le dix-sept octobre.
Pardevant Maître Robert SCHUMAN, notaire de résidence à Differdange.
ONT COMPARU:
1.- Madame Vânia REGUFE DA SILVA, salariée, née à Vila do Conde, Portugal, le 10 mars 1986 (Matricule 1986 0310
26356), demeurant à L-4575 Differdange, 53, Grand-Rue,
2.- Madame Diana ROSA DEVOGEL, salariée, née à Roncq, France, le 7 décembre 1987 (Matricule 1987 1207 52927),
demeurant à B-6791-Athus, 8, Grand-Rue
Lesquelles comparantes ont déclaré ce qui suit:
qu’elles sont les seules et uniques associées de la société à responsabilité limitée dénommée VANIA & DIANA S.à r.l.,
ayant son siège social à L-4320 Esch/Alzette, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 10
janvier 2013, publié au Mémorial C no 629 du 14 mars 2013;
que le capital social est fixé à douze mille cinq cents euro (€ 12.500.-), divisé en cent (100) parts sociales d’une valeur
nominale de cent vingt-cinq euro (€ 125.-) chacune;
que ladite société n’a plus d’activités depuis le 1
er
septembre 2013;
que les associées ont décidé la dissolution et la liquidation de la société et par conséquence elles se sont désignées
liquidateurs de ladite société;
qu’elles se déclarent investies de tout l’actif de la société;
qu’il n’existe à leur connaissance aucun passif à charge de la société et qu’elles s’engagent expressément solidairement
à régler tout passif éventuel;
que partant la société est à considérer comme définitivement dissoute et liquidée;
que les livres et documents comptables de la société dissoute resteront déposés et conservés pendant cinq ans à
l’adresse privée de Madame Vânia REGUFE DA SILVA, prénommée.
<i>Fraisi>
Les frais en rapport avec le présent acte resteront à la charge des anciens associées.
DONT ACTE, fait et passé à Differdange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, connues du notaire par noms, prénoms, états et
demeures, elles ont signé l’acte avec Nous Notaire.
Signé: Regufe Da Silva, Rosa Devogel, Schuman.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 22 octobre 2014. Relation: EAC / 2014 / 14209. Reçu soixante-quinze euros.
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande pour servir à des fins de dépôt au Registre de
Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg.
Differdange, le 29 octobre 2014.
Référence de publication: 2014168165/42.
(140191353) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2014.
171182
L
U X E M B O U R G
Azimut Europe, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 180.441.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Azimuth Europe S.à r.l.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2014168229/11.
(140192424) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2014.
Azimut Group, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 179.935.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Azimuth Group S.à r.l.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2014168230/11.
(140192523) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2014.
Blake S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 162.766.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014168262/9.
(140192788) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2014.
Dentsply S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 3.700.000,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 163.250.
<i>Extrait des décisions prises par l'associée unique et le conseil de gérance en date du 07 octobre 2014i>
1. Mme Mounira MEZIADI a démissionné de son mandat de gérant de catégorie B.
2. Mlle Ingrid CERNICCHI, administrateur de sociétés, née à Metz (France), le 18 Mai 1983, demeurant profession-
nellement à L-2453 Luxembourg 6, rue Eugène Ruppert, a été nommée comme gérant de catégorie B pour une durée
indéterminée.
3. Le siège social a été transféré de L1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande Duchesse Charlotte,-L-2453 Luxem-
bourg, 6, rue Eugène Ruppert.
Veuillez noter que les adresses professionnelles de Messieurs Andrew O'SHEA et Douwe TERPSTRA gérants de
catégorie B, se situent désormais au L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
Luxembourg, le 07 octobre 2014.
Pour extrait et avis sincères et conformes
<i>Pour Dentsply S.à r.l.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2014168337/21.
(140192495) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2014.
171183
L
U X E M B O U R G
Dahm Gaslog Luxembourg, Société Anonyme.
Siège social: L-8287 Kehlen, Zone Industrielle.
R.C.S. Luxembourg B 84.855.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 octobre 2014.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2014168344/12.
(140192620) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2014.
Dictame II S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 15, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 142.768.
EXTRAIT
Il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 24 octobre 2014 que le siège social de la société
est transféré du 9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg au 15, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg avec effet au
1
er
octobre 2014.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 29 octobre 2014.
Référence de publication: 2014168356/13.
(140192601) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2014.
Damrock S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 150.566.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30/10/2014.
G.T. Experts Comptables S.À.R.L.
Luxembourg
Référence de publication: 2014168347/12.
(140192140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2014.
HSH Investment Holdings FSO S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 188.150,00.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 140.592.
Par résolutions prises en date du 8 octobre 2014, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Nomination de Todd Freebern, avec adresse professionnelle au 767, Fifth Avenue, 23
rd
Floor, NY 10153 New
York, Etats-Unis, au mandat de gérant, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée;
2. Nomination de Sally Rocker, avec adresse professionnelle au 767, Fifth Avenue, 23
rd
Floor, NY 10153 New York,
Etats-Unis, au mandat de gérant, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée;
3. Révocation de Alexandra Petitjean, avec adresse professionnelle au 20, rue de la Poste, L-2346 de son mandat de
gérant, avec effet immédiat;
4. Révocation de Laëtitia Ambrosi avec adresse professionnelle au 20, rue de la Poste, L-2346 de son mandat de gérant,
avec effet immédiat;
5. Révocation de Luxembourg Corporation Company S.A., avec siège social au 20, rue de la Poste, L-2346 de son
mandat de gérant, avec effet immédiat.
171184
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 octobre 2014.
Référence de publication: 2014168444/21.
(140192592) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2014.
Forêt Vierge S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1149 Luxembourg, 400, rue des Sept-Arpents.
R.C.S. Luxembourg B 91.595.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30/10/2014.
G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg
Référence de publication: 2014168404/12.
(140192091) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2014.
Melody S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 181.788.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 24 octobre 2014i>
<i>Première résolutioni>
L'assemblée accepte les démissions de M. Donatello PIRLO, M. Yannick MONARDO et M. Massimo RASCHELLA de
leur mandat d'administrateur avec effet immédiat.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée nomme comme nouveaux administrateurs, leur mandant expirant à l'assemblée générale ordinaire devant
approuver les comptes au 31 décembre 2014:
- M. Pierre LENTZ, “licencié en sciences économiques”, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de
Gaulle, L-1653 Luxembourg;
- M. Philippe PONSARD, “ingénieur commercial”, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle,
L-1653 Luxembourg;
- M. Reno Maurizio TONELLI, “licencié en sciences politiques”, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles
de Gaulle, L-1653 Luxembourg.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée accepte la démission de Veridice, de son mandat de commissaire aux comptes avec effet immédiat.
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée nomme comme nouveau commissaire, AUDIEX S.A., ayant son siège social au 9, rue du Laboratoire,
L-1911 Luxembourg, son mandant expirant à l'assemblée générale ordinaire devant approuver les comptes au 31 dé-
cembre 2014.
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée décide de transférer le siège social de la société du 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg au 2,
avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 octobre 2014.
Référence de publication: 2014168566/31.
(140192441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2014.
Norden S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 134.135.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
171185
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 30/10/2014.
G.T. Experts Comptables S.À.R.L.
Luxembourg
Référence de publication: 2014168589/12.
(140192238) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2014.
Orbit Fund Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 123.749.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
Il résulte d'un acte de clôture de liquidation reçu par le notaire Maître Martine SCHAEFFER, de résidence à Luxem-
bourg, en date du 15 octobre 2014, enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 22 octobre 2014, LAC/2014/49238, aux
droits de soixante-quinze euro (75,- EUR), que la société à responsabilité limitée ORBIT FUND MANAGEMENT (en
liquidation volontaire), ayant son siège social à 11, Rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés sous le numéro B 123.749, constitué en date du 19 janvier 2007 par acte de Maître Joseph ELVINGER,
notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, numéro 72 du 30 janvier 2007.
La société a été mise en liquidation volontaire par acte du notaire instrumentaire en date du 8 janvier 2014, publié au
Mémorial C, numéro 734 du 21 mars 2014.
L'associé unique a présenté le rapport du commissaire à la liquidation.
Après avoir entendu le rapport du liquidateur et les comptes des liquidation ainsi que le rapport du commissaire à la
liquidation, l'associé unique les a approuvé.
L'associé unique a accordé décharge entier aux liquidateurs Monsieur Gerritt van NOORD et Monsieur Arnold BON
ainsi au commissaire à la liquidation FIDUCIAIRE PROBITAS.
Un solde en cash d'un montant de EUR 6.915,- (six mille neuf cent quinze euros) sera placé en dépôt auprès de Orbit
Private Asset Management S.A., afin de satisfaire les créanciers provisionnés.
Les actifs de la société seront mise à la disposition de l'associé unique.
En conséquence, l'associé unique a décidé la clôture de la liquidation de la société ORBIT FUND MANAGEMENT (en
liquidation volontaire).
Les livres et documents de la société seront conservés pour une période de 5 (cinq) ans suivant la liquidation de la
société dans les locaux de Orbit Private Asset Management S.A. au 11, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 octobre 2014.
Référence de publication: 2014168614/31.
(140191961) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2014.
Philippe Schmit architects, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7321 Müllendorf, 52, rue des Fraises.
R.C.S. Luxembourg B 148.722.
Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 octobre 2014.
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE ACCURA S.A.
<i>Experts comptables et fiscaux
i>Signature
Référence de publication: 2014168625/14.
(140192126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2014.
171186
L
U X E M B O U R G
PCM Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 106.212.
RECTIFICATIF
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés auprès du registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous la référence L130156713.
Ce dépôt est à remplacer par le dépôt suivant:
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour PCM Holding S.à r.l.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2014168637/15.
(140192121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2014.
Red Blue (France) Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 13.000.000,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 141.626.
Les comptes annuels au 30 septembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 Octobre 2014.
Red Blue (France) Properties S.à r.l.
Représenté par M. Stéphane HEPINEUZE
<i>Gérant Ai>
Référence de publication: 2014168661/13.
(140192599) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2014.
Pfaudler Midco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.
R.C.S. Luxembourg B 191.416.
STATUTES
In the year two thousand and thirteen, on the seventeenth day of October.
Before Maître Marc Loesch, notary, residing in Mondorf-les-Bains (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared the following:
Pfaudler Holding S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the Laws of Luxembourg, with a share capital
of twenty thousand United States Dollars (USD 20,000.-), having its registered office at 59, Rue de Rollingergrund, L-2440
Luxembourg, grand Duchy of Luxembourg, and in the process of being registered with the Luxembourg register of
Commerce and Companies,
represented by Me Stephan Weling, lawyer, professionally residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given in on 16 October 2014; such proxy, signed by the proxyholder and the
undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The following articles of incorporation of a company have then been drawn-up:
Chapter I. Form, Name, Registered office, Object, Duration
Art. 1. Form, Name. There is hereby established a société à responsabilité limitée (the “Company”) governed by the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg (the “Laws”) and by the present articles of incorporation (the “Articles of
Incorporation”).
The Company may be composed of one single shareholder, owner of all the shares, or several shareholders, but not
exceeding forty (40) shareholders.
The Company will exist under the name of “Pfaudler Midco S.à r.l.”.
Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office in the City of Luxembourg.
171187
L
U X E M B O U R G
The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by a resolution of the
Manager(s).
Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of
the Manager(s).
In the event that, in the view of the Manager(s), extraordinary political, economic or social developments occur or
are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of
communications with such office or between such office and persons abroad, the Company may temporarily transfer the
registered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will
have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office,
will remain a company governed by the Laws. Such temporary measures will be taken and notified to any interested
parties by the Manager(s).
Art. 3. Object. The object of the Company is the acquisition, holding and disposal of interests in Luxembourg and/or
in foreign companies and undertakings, as well as the administration, development and management of such interests.
The Company may provide loans and financing in any other kind or form or grant guarantees or security in any other
kind or form, in favour of the companies and undertakings forming part of the group of which the Company is a member.
The Company may also invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or immovable assets
in any kind or form.
The Company may borrow in any kind or form and privately issue bonds, notes or any other debt instruments as well
as warrants or other share subscription rights.
In a general fashion, the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem
useful in the accomplishment and development of its purposes.
Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
It may be dissolved at any time by a resolution of the shareholder(s), voting with the quorum and majority rules set
by the Laws or by the Articles of Incorporation, as the case may be pursuant to article 29 of the Articles of Incorporation.
Chapter II. Capital, Shares
Art. 5. Issued Capital. The issued capital of the Company is set at twenty thousand United States Dollars (USD 20,000.-)
divided into twenty thousand (20,000) shares with a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each, all of which
are fully paid up.
The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by the
Articles of Incorporation or by the Laws.
In addition to the issued capital, there may be set up a premium account to which any premium paid on any share in
addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment
of any shares which the Company may repurchase from its shareholder(s), to offset any net realised losses, to make
distributions to the shareholder(s) in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve.
Art. 6. Shares. Each share entitles to one vote.
Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common representative, whether appointed
amongst them or not.
When the Company is composed of a single shareholder, the single shareholder may freely transfer its shares.
When the Company is composed of several shareholders, the shares may be transferred freely amongst shareholders
but the shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of shareholders representing at least
three quarters (3/4) of the capital.
The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a private contract. Any such transfer is not binding
upon the Company or upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, pursuant to
article 1690 of the Luxembourg Civil Code.
The Company may acquire its own shares with a view to their immediate cancellation.
Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation and of the resolutions validly adopted
by the shareholder(s).
Art. 7. Increase and Reduction of Capital. The issued capital of the Company may be increased or reduced one or
several times by a resolution of the shareholder(s) adopted in compliance with the quorum and majority rules set by the
Articles of Incorporation or, as the case may be, by the Laws for any amendment of the Articles of Incorporation.
Art. 8. Incapacity, Death, Suspension of civil rights, Bankruptcy or Insolvency of a Shareholder. The incapacity, death,
suspension of civil rights, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting the shareholder(s) does not put the
Company into liquidation.
171188
L
U X E M B O U R G
Chapter III. Managers, Auditors
Art. 9. Managers. The Company shall be managed by one or several managers who need not be shareholders themselves
(the “Manager(s)”).
If two (2) Managers are appointed, they shall jointly manage the Company.
If more than two (2) Managers are appointed, they shall form a board of managers (the “Board of Managers”).
The Managers will be appointed by the shareholder(s), who will determine their number and the duration of their
mandate. The Managers are eligible for re-appointment and may be removed at any time, with or without cause, by a
resolution of the shareholder(s).
The shareholder(s) may decide to qualify the appointed Managers as class A Managers (the “Class A Managers”) or
class B Managers (the “Class B Managers”).
The shareholder(s) shall neither participate in nor interfere with the management of the Company.
Art. 10. Powers of the Managers. The Managers are vested with the broadest powers to perform all acts necessary
or useful for accomplishing the Company’s object.
All powers not expressly reserved by the Articles of Incorporation or by the Laws to the general meeting of shareholder
(s) or to the auditor(s) shall be within the competence of the Managers.
Art. 11. Delegation of Powers - Representation of the Company. The Manager(s) may delegate special powers or
proxies, or entrust determined permanent or temporary functions to persons or committees chosen by them.
The Company will be bound towards third parties by the individual signature of the sole Manager or by the joint
signatures of any two Manager(s) if more than one Manager has been appointed.
However, if the shareholder(s) have qualified the Managers as Class A Managers or Class B Managers, the Company
will only be bound towards third parties by the joint signatures of one Class A Manager and one Class B Manager.
The Company will further be bound towards third parties by the joint signatures or sole signature of any person to
whom special power has been delegated by the Manager(s), but only within the limits of such special power.
Art. 12. Meetings of the Board of Managers. In case a Board of Managers is formed, the following rules shall apply:
The Board of Managers may appoint from among its members a chairman (the “Chairman”). It may also appoint a
secretary, who need not be a Manager himself and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of
the Board of Managers (the “Secretary”).
The Board of Managers will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Managers must be convened
if any two (2) of its members so require.
The Chairman will preside over all meetings of the Board of Managers, except that in his absence the Board of Managers
may appoint another member of the Board of Managers as chairman pro tempore by majority vote of the Managers
present or represented at such meeting.
Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least three (3) calendar days’
written notice of meetings of the Board of Managers shall be given in writing and transmitted by any means of commu-
nication allowing for the transmission of a written text. Any such notice shall specify the time and the place of the meeting
as well as the agenda and the nature of the business to be transacted. The notice may be waived by properly documented
consent of each member of the Board of Managers. No separate notice is required for meetings held at times and places
specified in a time schedule previously adopted by resolution of the Board of Managers.
The meetings of the Board of Managers shall be held in Luxembourg or at such other place as the Board of Managers
may from time to time determine.
Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing, transmitted by any means of
communication allowing for the transmission of a written text, another Manager as his proxy. Any Manager may represent
one or several members of the Board of Managers.
A quorum of the Board of Managers shall be the presence or representation of at least half (1/2) of the Managers
holding office, provided that in the event that the Managers have been qualified as Class A Managers or Class B Managers,
such quorum shall only be met if at least one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager are present or represented.
Decisions will be taken by a majority of the votes of the Managers present or represented at such meeting.
One or more Managers may participate in a meeting by conference call, videoconference or any other similar means
of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other.
Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting.
A written decision, signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the
Board of Managers which was duly convened and held. Such a decision may be documented in a single document or in
several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Managers.
Art. 13. Resolutions of the Managers. The resolutions of the Manager(s) shall be recorded in writing.
The minutes of any meeting of the Board of Managers will be signed by the Chairman of the meeting and by the
secretary (if any). Any proxies will remain attached thereto.
171189
L
U X E M B O U R G
Copies or extracts of written resolutions or minutes, to be produced in judicial proceedings or otherwise, may be
signed by the sole Manager or by any two (2) Managers acting jointly if more than one Manager has been appointed.
Art. 14. Management Fees and Expenses. Subject to approval by the shareholder(s), the Manager(s) may receive a
management fee in respect of the carrying out of their management of the Company and may, in addition, be reimbursed
for all other expenses whatsoever incurred by the Manager(s) in relation to such management of the Company or the
pursuit of the Company’s corporate object.
Art. 15. Conflicts of Interest. If any of the Managers of the Company has or may have any personal interest in any
transaction of the Company, such Manager shall disclose such personal interest to the other Manager(s) and shall not
consider or vote on any such transaction.
In case of a sole Manager it suffices that the transactions between the Company and its Manager, who has such an
opposing interest, be recorded in writing.
The foregoing paragraphs of this Article do not apply if (i) the relevant transaction is entered into under fair market
conditions and (ii) falls within the ordinary course of business of the Company.
No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated
by the mere fact that any one or more of the Managers or any officer of the Company has a personal interest in, or is a
manager, associate, member, shareholder, officer or employee of such other company or firm. Any person related as
described above to any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall
not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering, voting
or acting upon any matters with respect to such contract or other business.
Art. 16. Managers’ Liability - Indemnification. No Manager commits himself, by reason of his functions, to any personal
obligation in relation to the commitments taken on behalf of the Company.
Manager(s) are only liable for the performance of their duties.
The Company shall indemnify any Manager, officer or employee of the Company and, if applicable, their successors,
heirs, executors and administrators, against damages and expenses reasonably incurred by him in connection with any
action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been Manager(s), officer or
employee of the Company, or, at the request of the Company, any other company of which the Company is a shareholder
or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally
adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct. In the event of a settlement,
indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Com-
pany is advised by its legal counsel that the person to be indemnified is not guilty of gross negligence or misconduct. The
foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which the persons to be indemnified pursuant to the
Articles of Incorporation may be entitled.
Art. 17. Auditors. Except where according to the Laws, the Company’s annual statutory and/or consolidated accounts
must be audited by an approved statutory auditor, the business of the Company and its financial situation, including in
particular its books and accounts, may, and shall in the cases provided by law, be reviewed by one or more statutory
auditors who need not be shareholders themselves.
The statutory or approved statutory auditors, if any, will be appointed by the shareholder(s), which will determine the
number of such auditors and the duration of their mandate. They are eligible for re-appointment. They may be removed
at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholder(s), save in such cases where the approved statutory
auditor may, as a matter of the Laws, only be removed for serious cause or by mutual agreement.
Chapter IV. Shareholders
Art. 18. Powers of the Shareholders. The shareholder(s) shall have such powers as are vested in them pursuant to the
Articles of Incorporation and the Laws. The single shareholder carries out the powers bestowed on the general meeting
of shareholders.
Any properly constituted general meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.
Art. 19. Annual General Meeting. The annual general meeting of shareholders, of which one must be held where the
Company has more than twenty-five (25) shareholders, will be held on the first day of the month of June.
If such day is a day on which banks are not generally open for business in Luxembourg, the meeting will be held on
the next following business day.
Art. 20. Other General Meetings. If the Company is composed of several shareholders, but no more than twenty-five
(25) shareholders, resolutions of the shareholders may be passed in writing. Written resolutions may be documented in
a single document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several
shareholders. Should such written resolutions be sent by the Manager(s) to the shareholders for adoption, the share-
holders are under the obligation to, within a time period of fifteen (15) calendar days from the dispatch of the text of the
proposed resolutions, cast their written vote by returning it to the Company through any means of communication
allowing for the transmission of a written text. The quorum and majority requirements applicable to the adoption of
resolutions by the general meeting of shareholders shall mutatis mutandis apply to the adoption of written resolutions.
171190
L
U X E M B O U R G
General meetings of shareholders, including the annual general meeting of shareholders will be held at the registered
office of the Company or at such other place in the Grand Duchy of Luxembourg, and may be held abroad if, in the
judgement of the Manager(s), which is final, circumstances of force majeure so require.
Art. 21. Notice of General Meetings. Unless there is only one single shareholder, the shareholders may also meet in
a general meeting of shareholders upon issuance of a convening notice in compliance with the Articles of Incorporation
or the Laws, by the Manager(s), subsidiarily, by the statutory auditor(s) (if any) or, more subsidiarily, by shareholders
representing more than half (1/2) of the capital.
The convening notice sent to the shareholders will specify the time and the place of the meeting as well as the agenda
and the nature of the business to be transacted at the relevant general meeting of shareholders. The agenda for a general
meeting of shareholders shall also, where appropriate, describe any proposed changes to the Articles of Incorporation
and, if applicable, set out the text of those changes affecting the object or form of the Company.
If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they have
been duly informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.
Art. 22. Attendance - Representation. All shareholders are entitled to attend and speak at any general meeting of
shareholders.
A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing in writing, transmitted by any means of
communication allowing for the transmission of a written text, another person who need not be a shareholder himself,
as a proxy holder.
Art. 23. Proceedings. Any general meeting of shareholders shall be presided over by the Chairman or by a person
designated by the Manager(s) or, in the absence of such designation, by the general meeting of shareholders.
The Chairman of the general meeting of shareholders shall appoint a secretary.
The general meeting of shareholders shall elect one (1) scrutineer to be chosen from the persons attending the general
meeting of shareholders.
The Chairman, the secretary and the scrutineer so appointed together form the board of the general meeting.
Art. 24. Vote. At any general meeting of shareholders other than a general meeting convened for the purpose of
amending the Articles of Incorporation of the Company or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum
and majority requirements of an amendment to the Articles of Incorporation, resolutions shall be adopted by shareholders
representing more than half (1/2) of the capital. If such majority is not reached at the first meeting (or consultation in
writing), the shareholders shall be convened (or consulted) a second time and resolutions shall be adopted, irrespective
of the number of shares represented, by a simple majority of votes cast.
At any general meeting of shareholders, convened in accordance with the Articles of Incorporation or the Laws, for
the purpose of amending the Articles of Incorporation of the Company or voting on resolutions whose adoption is subject
to the quorum and majority requirements of an amendment to the Articles of Incorporation, the majority requirements
shall be a majority of shareholders in number representing at least three quarters (3/4) of the capital.
Art. 25. Minutes. The minutes of the general meeting of shareholders shall be signed by the shareholders present and
may be signed by any shareholders or proxies of shareholders, who so request.
The resolutions adopted by the single shareholder shall be documented in writing and signed by the single shareholder.
Copies or extracts of the written resolutions adopted by the shareholder(s) as well as of the minutes of the general
meeting of shareholders to be produced in judicial proceedings or otherwise may be signed by the sole Manager or by
any two (2) Managers acting jointly if more than one Manager has been appointed.
Chapter V. Financial year, Financial statements, Distribution of profits
Art. 26. Financial Year. The Company's financial year begins on the first day of September of each year and ends on
the last day of August of the following year.
Art. 27. Adoption of Financial Statements. At the end of each financial year, the accounts are closed and the Manager
(s) draw up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss account, in accordance with
the Laws.
The annual statutory and/or consolidated accounts are submitted to the shareholder(s) for approval.
Each shareholder or its representative may peruse these financial documents at the registered office of the Company.
If the Company is composed of more than twenty-five (25) shareholders, such right may only be exercised within a time
period of fifteen (15) calendar days preceding the date set for the annual general meeting of shareholders.
Art. 28. Distribution of Profits. From the annual net profits of the Company, at least five per cent (5%) shall each year
be allocated to the reserve required by law (the “Legal Reserve”). That allocation to the Legal Reserve will cease to be
required as soon and as long as the Legal Reserve amounts to ten per cent (10%) of the issued capital of the Company.
After allocation to the Legal Reserve, the shareholder(s) shall determine how the remainder of the annual net profits
will be disposed of by allocating the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision, by carrying it forward
171191
L
U X E M B O U R G
to the next following financial year or by distributing it, together with carried forward profits, distributable reserves or
share premium to the shareholder(s), each share entitling to the same proportion in such distributions.
Subject to the conditions (if any) fixed by the Laws and in compliance with the foregoing provisions, the Manager(s)
may pay out an advance payment on dividends to the shareholders. The Manager(s) fix the amount and the date of payment
of any such advance payment.
Chapter VI. Dissolution, Liquidation
Art. 29. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a resolution of the shareholder(s) adopted by half
of the shareholders holding three quarters (3/4) of the capital.
Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by the Manager(s) or such other persons (who
may be physical persons or legal entities) appointed by the shareholder(s), who will determine their powers and their
compensation.
After payment of all the debts of and charges against the Company, including the expenses of liquidation, the net
liquidation proceeds shall be distributed to the shareholder(s) so as to achieve on an aggregate basis the same economic
result as the distribution rules set out for dividend distributions.
Chapter VII. Applicable law
Art. 30. Applicable Law. All matters not governed by the Articles of Incorporation shall be determined in accordance
with the Laws, in particular the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.
<i>Subscription and Paymenti>
The Articles of Incorporation of the Company having thus been recorded by the notary, the Company’s shares have
been subscribed and the nominal value of these shares, as well as a share premium, as the case may be, has been one
hundred per cent (100%) paid in cash as follows:
Shareholders
subscribed
capital
number of
ordinary
shares
amount
paid-in
Pfaudler Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 20,000.-
20,000 USD 20,000.-
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 20,000.-
20,000 USD 20,000.-
The amount of twenty thousand United States Dollars (USD 20,000.-) was thus as from that moment at the disposal
of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary who states that the conditions
provided for in article 183 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.
<i>Expensesi>
The amount of the costs, expenses, fees and charges, of any kind whatsoever, which are due from the Company or
charged to it as a result of its incorporation are estimated at approximately one thousand four hundred euro (EUR
1,400.-).
<i>Transitory Provisioni>
The first financial year of the Company will begin on the date of formation of the Company and will end on the last
day of August of 2015.
<i>Shareholders resolutionsi>
<i>First Resolutioni>
The general meeting of shareholders resolved to establish the registered office at 59, rue de Rollingergrund, L-2440
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
<i>Second Resolutioni>
The general meeting of shareholders resolved to set at two (2) the number of Manager(s) and further resolved to
appoint the following for an unlimited duration:
Mr. Stefan Gerhard Lambert, company manager, born on 8 January 1964 in Trier, Germany, residing professionally at
59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and
Dr. Wolfgang Michael Zettel, company manager, born on 15 November 1962 in Konstanz, Germany, residing profes-
sionally at 59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
The undersigned notary who knows and speaks English, stated that on request of the appearing person, the present
deed has been worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of divergences
between the English and the French text, the English text will prevail.
Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day referred to at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person(s), who is known to the undersigned notary by his surname,
first name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original deed.
171192
L
U X E M B O U R G
Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:
Im Jahre zweitausend und vierzehn, am siebzehnten Oktober.
Vor dem unterzeichnenden Notar, Maître Marc Loesch, mit dem Amtssitz in Mondorf-les-Bains, Großherzogtum
Luxemburg.
Ist erschienen:
Pfaudler Holding S.à r.l., eine société à responsabilité limitée luxemburgischen Rechts mit einem Grundkapital in Höhe
von zwanzigtausend US-Dollar (USD 20.000,-), mit Sitz in 59 Rue de Rollingergrund, L-2440 Luxemburg, Großherzogtum
Luxemburg, die sich zur Zeit in der Anmeldung beim Luxemburger Firmen- und Handelsregister befindet,
vertreten durch Maître Stephan Welilng, Rechtsanwalt, mit beruflichem Wohnsitz in Luxemburg,
kraft der am 16. Oktober 2014 privatschriftlichen erteilten Vollmacht.
Die oben genannte Vollmacht, welche von dem Vollmachtnehmer und dem unterzeichneten Notar unterzeichnet
wurde, bleibt der vorliegenden notariellen Urkunde zum Zwecke der Registrierung beigefügt.
Daraufhin wurde die Satzung einer Gesellschaft wie folgt festgestellt:
Kapitel I. Form, Name, Sitz, Gegenstand, Dauer
Art. 1. Form, Name. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (die „Gesellschaft“) gegründet, die
den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg (den „Gesetzen“) und den Bestimmungen der vorliegenden Satzung (die
„Satzung“) unterliegt.
Die Gesellschaft kann aus einem Alleingesellschafter, der Eigentümer aller Gesellschaftsanteile ist, oder aus mehreren
Gesellschaftern, deren Zahl jedoch vierzig (40) nicht überschreiten darf, bestehen.
Die Gesellschaft wird unter dem Namen „Pfaudler Midco S.à r.l.“ firmieren.
Art. 2. Sitz. Die Gesellschaft wird ihren Sitz in der Stadt Luxemburg haben.
Der Gesellschaftssitz kann durch einen Beschluss der (des) Geschäftsführer(s) an jeden anderen Ort innerhalb der
Stadt Luxemburg verlegt werden.
Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch einen Beschluss der (des) Geschäftsführer(s) ent-
weder im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.
Sollte(n) die (der) Geschäftsführer oder die Geschäftsführung der Auffassung sein, dass außergewöhnliche Ereignisse
politischer, wirtschaftlicher oder gesellschaftlicher Art aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, die die normale
Geschäftsführung der Gesellschaft am Gesellschaftssitz oder den Austausch mit der Geschäftsstelle am Gesellschaftssitz
beziehungsweise zwischen der Geschäftsstelle am Gesellschaftssitz und im Ausland befindlichen Personen beeinträchtigen
könnten, so kann die Gesellschaft den Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur völligen Beilegung der außergewöhnlichen
Ereignisse ins Ausland zu verlegen. Diese vorübergehenden Maßnahmen haben keinerlei Auswirkungen auf das Statut der
Gesellschaft, welche trotz der vorübergehenden Verlegung ihres Sitzes weiterhin den luxemburgischen Gesetzen unter-
liegt. Die genannten vorübergehenden Maßnahmen sind von der Geschäftsführung zu beschließen und den hiervon
betroffenen Dritten mitzuteilen.
Art. 3. Gesellschaftszweck. Der Zweck der Gesellschaft umfasst die Akquisition, das Halten und die Veräußerung von
Beteiligungen in luxemburgischen und/oder ausländischen Unternehmen, sowie die Verwaltung, Entwicklung und Betreu-
ung solcher Beteiligungen.
Die Gesellschaft kann zugunsten von Unternehmen, welche der Unternehmensgruppe angehören, jede finanzielle Un-
terstützung gewähren, wie zum Beispiel die Gewährung von Darlehen, Garantien und Sicherheiten jeglicher Art und Form.
Die Gesellschaft kann auch in Immobilien, geistiges Eigentum oder jegliche andere bewegliche oder unbewegliche
Vermögensgüter investieren.
Die Gesellschaft kann in jeder Art und Form Darlehen aufnehmen und private Emissionen von Schuldscheinen oder
ähnlichen Schuldtiteln oder Warrants oder ähnliche Anteile, die Recht auf Aktien geben, ausgeben.
Generell kann die Gesellschaft jede kommerzielle, industrielle oder finanzielle Tätigkeit ausführen, welche für die
Ausführung und Entwicklung ihres Zweckes dienlich ist.
Art. 4. Dauer. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.
Sie kann jederzeit aufgelöst werden durch einen Beschluss des/der Gesellschafter, der in Übereinstimmung mit dem
nach dem Gesetz oder dieser Satzung für die Änderung der Satzung erforderlichen Quorum und den erforderlichen
Mehrheiten gefasst wird, und in Übereinstimmung mit Artikel 29 dieser Satzung.
Kapitel II. Kapital, Anteile
Art. 5. Ausgegebenes Gesellschaftskapital. Das ausgegebene Kapital der Gesellschaft beträgt zwanzigtausend USDollar
(USD 20.000,-), und ist in zwanzigtausend (20.000) Anteile mit einem Nennwert von je einem US-Dollar (USD 1,-)
aufgeteilt. Alle Anteile sind vollständig eingezahlt.
Vorbehaltlich gegenteiliger Bestimmungen der Satzung oder des Gesetzes sind alle Anteile mit denselben Rechten und
Pflichten ausgestattet.
171193
L
U X E M B O U R G
Zusätzlich zum ausgegebenen Gesellschaftskapital kann ein Aufgeldkonto eingerichtet werden auf das alle Emissions-
aufgelder, die auf einen Anteil eingezahlt werden, verbucht werden. Der Betrag dieses Aufgeldkontos kann zur Zahlung
von Anteilen, die die Gesellschaft von ihrem(n) Gesellschafter(n) zurückkauft, zum Ausgleich von realisierten Nettover-
lusten, zur Auszahlung an den/die Gesellschafter in Form von Dividenden oder um Mittel zur gesetzlichen Rücklage
bereitzustellen, verwendet werden.
Art. 6. Anteile. Jeder Anteil berechtigt zu einer Stimme.
Jeder Anteil ist der Gesellschaft gegenüber unteilbar.
Gemeinschaftliche Eigentümer von Anteilen müssen sich gegenüber der Gesellschaft durch einen gemeinsamen Be-
vollmächtigten, der auch ein Dritter sein kann, vertreten lassen.
Der Alleingesellschafter kann seine Anteile frei übertragen.
Besteht die Gesellschaft aus mehreren Gesellschaftern, so sind die Anteile unter ihnen frei übertragbar und die Anteile
können nur dann an Nicht-Gesellschafter übertragen werden, wenn die Gesellschafter mit einer Mehrheit, die mindestens
drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals darstellt, ihr Einverständnis erklären.
Die Übertragung von Anteilen muss durch notarielle Urkunde oder durch privatschriftlichen Vertrag belegt werden.
Eine solche Übertragung wird gemäß Artikel 1690 des Bürgerlichen Gesetzbuches Luxemburgs erst dann gegenüber der
Gesellschaft oder Dritten bindend, wenn sie der Gesellschaft gegenüber ordnungsgemäß angezeigt oder von dieser an-
genommen worden ist.
Die Gesellschaft ist berechtigt ihre eigenen Anteile im Hinblick auf deren sofortige Annullierung zurückzuerwerben.
Anteilsbesitz führt die stillschweigende Akzeptanz der Satzung und der von den (dem) Gesellschafter(n) gültig getrof-
fenen Beschlüsse mit sich.
Art. 7. Kapitalerhöhung und Kapitalherabsetzung. Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der (des) Ge-
sellschafter(s), der mit Anwesenheits- und Mehrheitsverhältnissen, wie sie aufgrund der Gesetze oder der Satzung zur
Änderung der Satzung erforderlich sind, gefasst wird, einmal oder mehrmals erhöht oder herabgesetzt werden.
Art. 8. Handlungsunfähigkeit, Tod, Aussetzung von Bürgerrechten, Konkurs oder Insolvenz eines Gesellschafters. Die
Handlungsunfähigkeit, der Tod, die Aussetzung von Bürgerrechten, der Konkurs oder die Insolvenz oder ein vergleich-
barer, die (den) Gesellschafter betreffender Umstand, hat nicht die Auflösung der Gesellschaft zur Folge.
Kapitel III. Geschäftsführer, Wirtschaftsprüfer
Art. 9. Geschäftsführer. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern, welche keine Gesellschaf-
ter sein müssen, geführt (die (der) „Geschäftsführer“).
Werden zwei (2) Geschäftsführer bestellt, so verwalten sie die Gesellschaft gemeinschaftlich.
Werden mehr als zwei (2) Geschäftsführer bestellt, so wird ein Geschäftsführungsrat (der „Geschäftsführungsrat“)
gegründet.
Die Geschäftsführer werden durch die (den) Gesellschafter ernannt, welche(r) ihre Anzahl und die Dauer ihres Mandats
festlegt. Die (der) Geschäftsführer können wiederernannt werden und können jederzeit, mit oder ohne Grund, durch
einen Beschluss der (des) Gesellschafter(s) abberufen werden.
Die (der) Gesellschafter können (kann) beschließen, die gewählten Geschäftsführer als Geschäftsführer A (der (die)
„Geschäftsführer A“)) oder als Geschäftsführer B (die (der) „Geschäftsführer B“)) zu qualifizieren.
Der/die Gesellschafter soll(en) weder an der Geschäftsführung teilnehmen noch sich in diese einmischen.
Art. 10. Befugnisse der (des) Geschäftsführer(s). Die (der) Geschäftsführer haben (hat) die weitestgehenden Befugnisse,
um alle zur Erreichung des Gesellschaftszwecks notwendigen oder nützlichen Handlungen vorzunehmen.
Sämtliche Befugnisse, die die Satzung oder die Gesetze nicht ausdrücklich den Gesellschaftern oder den Wirtschafts-
prüfern vorbehalten, fallen in die Zuständigkeit der (des) Geschäftsführer(s).
Art. 11. Übertragung von Befugnissen - Vertretung der Gesellschaft. Die (der) Geschäftsführer können (kann) spezielle
Befugnisse oder Vollmachten an Personen oder Ausschüsse, die von ihnen gewählt werden, übertragen oder diese mit
bestimmten ständigen oder zeitweiligen Funktionen ausstatten.
Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber durch die alleinige Unterschrift des einzigen Geschäftsführers oder, wenn
mehr als ein Geschäftsführer ernannt worden ist, durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Geschäftsführern, gebun-
den.
Falls die (der) Gesellschafter die Geschäftsführer als Geschäftsführer A oder als Geschäftsführer B qualifiziert haben
(hat), ist die Gesellschaft Dritten gegenüber nur gebunden, wenn ein Geschäftsführer A und ein Geschäftsführer B ge-
meinsam unterzeichnen.
Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber auch durch die gemeinsame oder alleinige Unterschrift derjenigen Personen
gebunden, denen eine spezielle Vollmacht von dem (den) Geschäftsführer(n) übertragen worden ist, jedoch nicht über
die Grenzen dieser speziellen Vollmacht hinaus.
171194
L
U X E M B O U R G
Art. 12. Sitzung des Geschäftsführungsrates. Für den Fall, dass ein Geschäftsführungsrat bestellt wird, gelten folgende
Regeln:
Der Geschäftsführungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden benennen (der „Vorsitzende“). Er kann auch einen
Schriftführer benennen, welcher selbst kein Geschäftsführer sein muss und für die Protokollführung der Sitzung der
Geschäftsführung zuständig ist (der „Schriftführer“).
Der Geschäftsführungsrat tritt nach Aufruf durch den Vorsitzenden zusammen. Eine Versammlung des Geschäftsfüh-
rungsrates muss einberufen werden, wenn zwei (2) seiner Mitglieder dies verlangen.
Der Vorsitzende steht allen Versammlungen des Geschäftsführungsrates vor, es sei denn, dass in seiner Abwesenheit
der Geschäftsführungsrat ein anderes Mitglied des Geschäftsführungsrates durch mehrheitliche Abstimmung durch die
anwesenden oder vertretenen Mitglieder als zeitweisen Vorsitzenden ernennt.
Außer in Dringlichkeitsfällen oder mit vorheriger Zustimmung aller Teilnahmeberechtigten, werden die Sitzungen des
Geschäftsführungsrates mindestens drei (3) Kalendertage vor ihrem Termin schriftlich durch ein die Schriftlichkeit ge-
währleistendes Kommunikationsmittel einberufen. Jede dieser Benachrichtigungen soll Ort und Zeit der Sitzung sowie
die Tagesordnung und die Art der zu behandelnden Geschäftstätigkeit angeben. Auf die Mitteilung kann durch ordnungs-
gemäß dokumentierten Beschluss jedes Geschäftsführungsmitglieds verzichtet werden. Für Sitzungen, deren Zeit und Ort
in einem zuvor von der Geschäftsführung angenommenen Beschluss festgelegt wurde, ist keine gesonderte Benachrich-
tigung erforderlich.
Die Sitzungen des Geschäftsführungsrates finden in Luxemburg oder an einem anderen Ort statt, den die Geschäfts-
führung von Zeit zu Zeit bestimmen kann.
Jeder Geschäftsführer kann sich bei den Sitzungen des Geschäftsführungsrates durch ein anderes Mitglied des Ge-
schäftsführungsrates vertreten lassen, indem er dieses hierzu schriftlich ermächtigt; die Bevollmächtigung kann durch jedes
die Schriftlichkeit gewährleistendes Kommunikationsmedium übertragen werden. Jeder Geschäftsführer kann einen oder
mehrere Geschäftsführer vertreten.
Die Beschlussfähigkeit des Geschäftsführungsrates erfordert die Anwesenheit von mindestens der Hälfte (1/2) seiner
amtierenden Mitglieder, wobei im Falle der Qualifizierung der Geschäftsführer als Geschäftsführer A oder als Geschäfts-
führer B, außerdem mindestens ein (1) Geschäftsführer A und ein (1) Geschäftsführer B anwesend oder vertreten sein
muss.
Entschlüsse werden per Mehrheitsbescheid aller bei der Sitzung anwesenden oder vertretenen Mitglieder des Ge-
schäftsführungsrates gefasst.
Ein oder mehrere Mitglieder des Geschäftsführungsrates können an Sitzungen durch eine Telefonkonferenzschaltung
oder durch ähnliche Mittel, welche die gleichzeitige Kommunikation zwischen den Teilnehmern sicherstellen, teilnehmen.
Diese Teilnahmeform wird der persönlichen Anwesenheit bei der Sitzung gleichgestellt.
Eine von allen Geschäftsführern unterzeichnete Entscheidung steht einem Beschluss gleich, der in einer ordnungsgemäß
einberufenen und abgehaltenen Sitzung des Geschäftsführungsrates gefasst worden wäre. Ein solcher Beschluss kann
festgehalten werden in einem einzigen Dokument oder in mehreren getrennten Dokumenten desselben Inhalts und jeweils
von einem oder mehreren Geschäftsführern unterzeichnet.
Art. 13. Beschlüsse der Geschäftsführung. Die Beschlüsse der(s) Geschäftsführer(s) werden schriftlich festgehalten.
Alle Sitzungsprotokolle werden vom Vorsitzenden und vom Schriftführer (falls es einen solchen gibt) unterzeichnet.
Alle Vollmachten werden den betreffenden Sitzungsprotokollen beigefügt.
Kopien oder Auszüge der schriftlichen Beschlüsse oder Sitzungsprotokolle, die in rechtlichen Verfahren oder ander-
weitig übermittelt werden, können von einem Geschäftsführer oder durch zwei (2) Geschäftsführer gemeinsam, wenn
mehr als ein Geschäftsführer ernannt wurde, unterzeichnet werden.
Art. 14. Vergütung und Ausgaben. Vorbehaltlich der Zustimmung durch die (den) Gesellschafter, können (kann) die
(der) Geschäftsführer eine Vergütung hinsichtlich ihrer (seiner) Verwaltung der Gesellschaft erhalten. Darüber hinaus
können den Geschäftsführern sämtliche Ausgaben, die im Rahmen einer solchen Verwaltung oder zur Verfolgung des
Gesellschaftsgegenstandes getätigt wurden, zurückerstattet werden.
Art. 15. Interessenkonflikte. Wenn einer der Geschäftsführer der Gesellschaft ein persönliches Interesse an einem
Rechtsgeschäft der Gesellschaft hat oder haben könnte, muss er dieses persönliche Interesse den anderen Geschäfts-
führern anzeigen und darf nicht an der Abstimmung über dieses Rechtsgeschäft teilnehmen.
Falls es nur einen Geschäftsführer gibt, genügt es, dass das Rechtsgeschäft zwischen der Gesellschaft und ihrem Ge-
schäftsführer, der ein entgegengesetztes Interesse hat, schriftlich festgehalten wird.
Die vorstehenden Bestimmungen sind nicht anwendbar wenn (i) das betreffende Rechtsgeschäft unter fairen Markt-
bedingungen eingegangen wurde und (ii) in die gewöhnlichen Geschäftsabläufe der Gesellschaft fällt.
Kein Vertrag oder sonstiges Rechtsgeschäft zwischen der Gesellschaft und irgendeiner anderen Gesellschaft oder
irgend einem anderen Unternehmen wird durch den bloßen Umstand beeinträchtigt oder ungültig, dass ein oder mehrere
Geschäftsführer oder Bevollmächtigte der Gesellschaft persönlich an einer solchen Gesellschaft oder einem solchen
Unternehmen beteiligt sind oder Geschäftsführer, Gesellschafter, Bevollmächtigte(r) oder Angestellte(r) einer solchen
Gesellschaft oder eines solchen Unternehmens sind. Keine Person, welche in einer der zuvor beschriebenen Weise mit
171195
L
U X E M B O U R G
einer Gesellschaft oder einem Unternehmen in Beziehung steht, mit der beziehungsweise dem die Gesellschaft vertrag-
liche Beziehungen eingeht oder sonst wie Geschäfte tätigt, wird automatisch daran gehindert über solche Verträge oder
andere Geschäfte zu beraten, abzustimmen oder zu handeln.
Art. 16. Haftung der Geschäftsführung - Freistellung. Die (der) Geschäftsführer treffen (trifft) keine persönliche Haftung
hinsichtlich der aufgrund ihrer (seiner) Funktion für die Gesellschaft eingegangenen Verpflichtungen.
Geschäftsführer sind für die Ausführung ihrer Aufgaben verantwortlich.
Die Gesellschaft stellt jeden Geschäftsführer, Angestellten oder Mitarbeiter und, gegebenenfalls, dessen Erben, Nach-
lassverwalter und Vermögensverwalter, von Schäden und Ausgaben frei, die ihm im Zusammenhang eines Rechtsstreits
oder eines Prozesses, an dem er aufgrund seiner Funktion als Geschäftsführer oder früherer Geschäftsführer, Angestellter
oder Mitarbeiter der Gesellschaft beteiligt ist. Das Gleiche gilt, wenn er auf Anfrage der Gesellschaft für eine andere
Gesellschaft an der die Gesellschaft beteiligt ist oder von der sie Gläubigerin ist, Ausgaben tätigt und der gegenüber er
nicht zur Freistellung berechtigt ist, außer bei Klagsachen in denen er schließlich endgültig wegen grober Fahrlässigkeit
oder Misswirtschaft verurteilt wurde. Im Falle eines Vergleichs wird Freistellung nur für vom Vergleich umfasste Fragen
gewährt, bei denen die Gesellschaft von ihrem Rechtsbeistand dahingehend beraten worden ist, dass der freizustellenden
Person keine grobe Fahrlässigkeit oder grobes Fehlverhalten vorzuwerfen ist. Das vorgenannte Recht zur Freistellung
schließt keine anderen Rechte aus zu denen die betreffende Person berechtigt ist.
Art. 17. Wirtschaftsprüfer. Außer in den Fällen, in denen die gesetzlichen Bestimmungen die Prüfung der Jahresab-
schlüsse und konsolidierten Jahresabschlüsse durch einen zugelassenen Wirtschaftsprüfer vorsehen, wird das Geschäft
der Gesellschaft und deren finanzielle Situation, einschließlich insbesondere der Bücher und Konten durch Wirtschafts-
prüfer, welche nicht Gesellschafter zu sein brauchen, geprüft.
Die statutorischen oder zugelassenen Wirtschaftsprüfer, falls es solche gibt, werden durch die (den) Gesellschafter
ernannt, der ihre Anzahl und die Dauer ihres Mandats festlegt. Die Wirtschaftsprüfer können wiederernannt werden und
können jederzeit, mit oder ohne Grund, durch einen Beschluss der (des) Gesellschafter(s) abberufen werden außer in
Fällen, in denen das Gesetz vorschreibt, dass der zugelassene Wirtschaftsprüfer nur aufgrund schwerwiegendem Grund
oder in gegenseitigem Einverständnis abberufen werden kann.
Kapitel IV. Gesellschafter
Art. 18. Befugnisse der Gesellschafter. Die Gesellschafter haben die Rechte, die ihnen nach der Satzung und dem Gesetz
zustehen. Besteht die Gesellschaft nur aus einem Gesellschafter, so übt dieser die Befugnisse aus, die das Gesetz der
Gesellschafterversammlung übertragen hat.
Jede ordnungsgemäß zusammengetretene Gesellschafterversammlung repräsentiert alle Gesellschafter.
Art. 19. Jahresgesellschafterversammlung. Die Jahresgesellschafterversammlung, die verpflichtend abgehalten werden
muss wenn die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, wird am ersten Tag des Monats Juli abge-
halten.
Wenn dieser Tag ein Tag ist an dem Banken in Luxemburg nicht geöffnet sind, wird die Versammlung am darauffol-
genden Werktag abgehalten.
Art. 20. Andere Gesellschafterversammlungen. Besteht die Gesellschaft aus mehreren, jedoch nicht mehr als fünfund-
zwanzig (25) Gesellschaftern, können die Beschlüsse der Gesellschafter in schriftlicher Form gefasst werden. Schriftliche
Beschlüsse können in einem einzigen Dokument oder in mehreren getrennten Dokumenten desselben Inhalts und jeweils
von einem oder mehreren Gesellschaftern unterzeichnet festgehalten sein. Sind die zu fassenden Beschlüsse von den
Geschäftsführern an die Gesellschafter übermittelt worden, so sind die Gesellschafter verpflichtet innerhalb von fünfzehn
(15) Kalendertagen seit dem Eingang des Textes des vorgeschlagenen Beschlusses ihre Entscheidung zu treffen und sie
der Gesellschaft durch jedes, die Schriftlichkeit gewährleistendes Kommunikationsmittel, zukommen zu lassen. Die Be-
stimmungen zur Beschlussfähigkeit und den erforderlichen Mehrheiten bei Beschlüssen der Gesellschafterversammlung
sind sinngemäß auf die Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren anwendbar.
Gesellschafterversammlungen, einschließlich der Jahresgesellschafterversammlung werden am Gesellschaftssitz abge-
halten oder an jedem anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg; sie können im Ausland abgehalten werden, wenn
Umstände höherer Gewalt, deren Einschätzung im alleinigen Interesse des (der) Geschäftsführer(s) liegt, dies erforderlich
machen.
Art. 21. Mitteilung von Gesellschafterversammlungen. Außer in den Fällen eines Alleingesellschafters, können sich die
Gesellschafter auch auf Einberufungsschreiben versammeln, das in Übereinstimmung mit der Satzung oder dem Gesetz
von den Geschäftsführern, oder andernfalls durch die statutorischen Wirtschaftsprüfer (falls vorhanden) ausgegeben wird
oder andernfalls durch Gesellschafter, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals repräsentieren.
Das an die Gesellschafter gesendete Einberufungsschreiben gibt die Zeit, den Ort und die Tagesordnung der Gesell-
schafterversammlung an sowie die Eigenart der zu behandelnden Geschäftstätigkeit. Die Tagesordnung soll gegebenenfalls
eine vorgeschlagene Satzungsänderung darlegen und gegebenenfalls die Änderungen angeben, die den Gesellschaftszweck
oder die Rechtsform der Gesellschaft betreffen.
171196
L
U X E M B O U R G
Sind alle Gesellschafter bei der Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten und erklären sie, dass sie über
die Tagesordnung ordnungsgemäß in Kenntnis gesetzt worden sind, so kann die Versammlung ohne vorherige Einberufung
abgehalten werden.
Art. 22. Anwesenheit - Vertretung. Alle Gesellschafter besitzen bei jeder Gesellschafterversammlung ein Teilnahme-
und Rederecht.
Ein Gesellschafter kann sich durch schriftliche Ermächtigung, welche durch ein die Schriftlichkeit gewährleistendes
Kommunikationsmittel übermittelt wurde, bei jeder Gesellschafterversammlung durch eine andere Person, die nicht selbst
Gesellschafter sein muss, vertreten lassen.
Art. 23. Verfahren. Den Vorsitz der Gesellschafterversammlung führt der Vorsitzende oder eine Person, die hierzu
von den Geschäftsführern oder andernfalls durch die Gesellschafterversammlung ernannt wird.
Der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung ernennt einen Schriftführer.
Die Gesellschafterversammlung ernennt einen (1) Stimmzähler, der unter den Personen, die bei der Gesellschafter-
versammlung anwesend sind, gewählt wird.
Der Vorsitzende, der Schriftführer und der Stimmzähler bilden zusammen den Vorstand der Gesellschafterversamm-
lung.
Art. 24. Abstimmung. Bei jeder Gesellschafterversammlung, die nicht einberufen wurde zur Änderung der Satzung
oder zur Fassung von Beschlüssen, die den Mehrheitsverhältnissen, wie sie zur Änderung der Satzung erforderlich sind,
unterliegen, werden Beschlüsse von Gesellschaftern gefasst, die mehr als die Hälfte (1/2) des Gesellschaftskapitals reprä-
sentieren.
Wenn eine solche Mehrheit nicht bei der ersten Versammlung oder bei dem ersten Versuch einer schriftlichen Be-
schlussfassung erreicht wird, werden die Gesellschafter ein zweites Mal einberufen oder konsultiert; Beschlüsse werden
dann unabhängig von der Anzahl der vertretenen Aktien, durch einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.
Bei jeder Gesellschafterversammlung, die in Übereinstimmung mit der Satzung oder den Gesetzen zum Zwecke der
Satzungsänderung oder zur Abstimmung über Beschlüsse, die den Mehrheitsverhältnissen, wie sie zur Änderung der
Satzung erforderlich sind, unterliegen, einberufen wird, entsprechen die Mehrheitsverhältnisse der Mehrheit der Anzahl
der Gesellschafter, die mindestens drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals repräsentieren.
Art. 25. Protokolle. Das Protokoll der Gesellschafterversammlung wird von den anwesenden Gesellschaftern unter-
zeichnet und kann von Gesellschaftern, oder Vertretern von Gesellschaftern, die dies verlangen, unterzeichnet werden.
Die vom Alleingesellschafter gefassten Beschlüsse werden schriftlich festgehalten und von dem Alleingesellschafter
unterzeichnet.
Kopien oder Auszüge der von den (dem) Gesellschafter(n) angenommenen Beschlüsse sowie des Sitzungsprotokolls
der Gesellschafterversammlung, die in rechtlichen Verfahren oder anderweitig übermittelt werden, können von einem
Geschäftsführer oder durch zwei (2) Geschäftsführer gemeinsam, wenn mehr als ein Geschäftsführer ernannt worden
ist, unterzeichnet werden.
Kapitel V. Geschäftsjahr, Finanzberichte, Ausschüttung von gewinnen
Art. 26. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten September eines jeden Jahres und endet
am einunddreißigsten August des darauf folgenden Jahres.
Art. 27. Annahme der Finanzberichte. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden die Konten geschlossen und die
Geschäftsführer erstellen in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen ein Verzeichnis der Vermögensanlagen
und Verpflichtungen sowie die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung.
Der Jahresabschluss und/oder der konsolidierte Jahresabschluss (werden) wird den (dem) Gesellschafter(n) vorgelegt.
Jeder Gesellschafter kann in diese Finanzdokumente am Gesellschaftssitz einsehen. Besteht die Gesellschaft aus mehr
als fünfundzwanzig (25) Gesellschaftern, kann dieses Recht nur während einer Zeitspanne von fünfzehn (15) Kalendertagen
bis zum Datum der jährlichen Hauptversammlung ausgeübt werden.
Art. 28. Gewinnverteilung. Von dem jährlichen Reingewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der
gesetzlich vorgesehenen Rücklage zugewiesen (die „Rücklage“). Diese Verpflichtung entfällt sobald und solange diese
Rücklage die Höhe von zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals erreicht.
Nach der Zuweisung zur gesetzlichen Rücklage bestimmen die Gesellschafter wie der verbleibende jährliche Reinge-
winn verteilt werden soll indem sie diesen vollständig oder teilweise einer Rücklage zuweisen, auf das nächste Geschäfts-
jahr vortragen oder, zusammen mit vorgetragenen Gewinnen, ausschüttbaren Rücklagen oder Ausgabeprämien an die
Gesellschafter ausschütten, wobei jeder Anteil in gleichem Verhältnis zur Teilnahme an einer solchen Ausschüttung be-
rechtigt.
Vorbehaltlich der (gegebenenfalls) gesetzlich vorgeschriebenen Bedingungen und unter Berücksichtigung der vorste-
henden Bestimmungen, können die Geschäftsführer eine Abschlagsdividende an die Gesellschafter auszahlen. Die
Geschäftsführer legen die Summe und das Datum einer solchen Abschlagszahlung fest.
171197
L
U X E M B O U R G
Kapitel VI. Auflösung, Liquidation
Art. 29. Auflösung, Liquidation. Die Gesellschaft kann durch einen Entschluss der (des) Gesellschafter(s) aufgelöst
werden, der durch die Hälfte der Gesellschafter gefasst wird, die mindestens drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals
repräsentieren.
Sollte die Gesellschaft aufgelöst werden, so wird die Liquidation durch die (den) Geschäftsführer oder andere (natür-
liche oder juristische) Personen durchgeführt, deren Befugnisse und Vergütung von den (dem) Gesellschafter(n) bestimmt
werden.
Nach Begleichung aller Schulden und sonstiger gegen die Gesellschaft bestehenden Ansprüche einschließlich der Li-
quidationskosten wird der Reinerlös aus der Abwicklung an die Gesellschafter so verteilt, dass das wirtschaftliche Ergebnis
den auf die Ausschüttung von Dividenden anwendbaren Regeln entspricht.
Kapitel VII. Anwendbares recht
Art. 30. Anwendbares Recht. Sämtliche Angelegenheiten, die nicht durch die vorliegende Satzung geregelt sind, be-
stimmen sich nach den Gesetzen, insbesondere dem Gesetz über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915, in der
zuletzt geltenden Fassung.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Die Satzung ist somit durch den Notar aufgenommen, die Anteile wurden gezeichnet und der Nennwert und gege-
benenfalls das Emissionsaufgeld zu einhundert Prozent (100%) in bar wie folgt eingezahlt:
Gesellschafter
Gezeichnetes
Kapital
Anzahl
Stammanteile
Eingezahlter
Betrag
Pfaudler Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 20.000,-
20.000 USD 20.000,-
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 20.000,-
20.000 USD 20.000,-
Die Summe von zwanzigtausend US-Dollar (USD 20.000,-) stand der Gesellschaft daher von diesem Zeitpunkt an zur
Verfügung. Nachweis hierüber wurde dem unterzeichnenden Notar erbracht, welcher erklärt, dass die Maßgaben von
Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915, in der zuletzt geltenden Fassung, erfüllt
wurden.
<i>Kosteni>
Die Höhe der Auslagen, Kosten, Aufwendungen und Lasten jeglicher Art, die der Gesellschaft aufgrund ihrer Gründung
entstehen, werden auf ungefähr eintausendvierhundert Euro (EUR 1.400,-) geschätzt.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Gründungstag der Gesellschaft und endet am letzten Tag des Monats August des
Jahres 2015.
<i>Gesellschafterbeschlüssei>
<i>Erster Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung hat beschlossen, den Sitz der Gesellschaft in 59, rue de Rollingergrund, L-2440 Lu-
xemburg Großherzogtum Luxemburg, festzulegen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Anzahl der Geschäftsführer wird auf zwei (2) festgelegt und die folgenden Personen werden auf unbegrenzte Zeit
als Geschäftsführer ernannt:
Herr Stefan Gerhard Lambert, geboren am 8. Januar 1964 in Trier, mit beruflicher Anschrift in 59, rue de Rollinger-
grund, L-2440 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg; und
Herr Dr. Wolfgang Michael Zettel, geboren am 15. November 1962 in Konstanz, mit beruflicher Anschrift in 59, rue
de Rollingergrund, L-2440 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg.
Der unterzeichnende Notar, der Englisch spricht, erklärt, dass vorliegende Urkunde auf Antrag der oben genannten
Partei in englischer Sprache verfasst wurde, der eine deutsche Fassung folgt; auf Antrag derselben Personen und im Falle
von Abweichungen zwischen dem deutschen und dem englischen Text gilt der englische Text.
Worüber Urkunde, Aufgenommen in Luxemburg, am eingangs erwähnten Datum.
Nachdem das Dokument den dem Notar nach Namen, Vornamen, Personenstand und Wohnort bekannten, erschie-
nenen Partei vorgelesen worden ist, hat derselbe vorliegende urschriftliche Urkunde mit dem unterzeichnenden Notar,
unterzeichnet.
Signé: S. Weling, M. Loesch.
Enregistré à Remich, le 22 octobre 2014. REM/2014/2299. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
Pour expédition conforme,
171198
L
U X E M B O U R G
Mondorf-les-Bains, le 31 octobre 2014.
Référence de publication: 2014169320/634.
(140193107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2014.
Daripod Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 6.878.410,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 185.028.
In the year two thousand and fourteen on the fourteenth day of August,
Before, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
There appeared:
- Edenred Luxembourg S.A., a public limited company organized and existing under the laws of Luxembourg, with
registered office at 46a, Avenue John F. Kennedy, 1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with
the Register of Commerce and Companies of Luxembourg under No. B 42434;
here represented by Régis Galiotto, notary clerk, residing professionally at 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg, by
virtue of a proxy given on 12 August 2014;
- Azeed Group Inc., a company limited by shares organized and existing under the laws of the British Virgin Islands,
with registered office at First Floor, Mandar House, Johnson’s Ghut, P.O. Box 3257, Road Town, Tortola, British Virgin
Islands and registered with the British Virgin Islands’ Registry of Corporate Affairs under the number 1661134;
here represented by Régis Galiotto, notary clerk, residing professionally at 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg, by
virtue of a proxy given on 12 August 2014;
- Uline Commercial Inc., a company limited by shares organized and existing under the laws of the British Virgin Islands,
with registered office at Geneva Place, Waterfront Drive, P.O. Box 3469, Road Town, Tortola, British Virgin Islands and
registered with the British Virgin Islands’ Registry of Corporate Affairs under the number 1585137;
here represented by Régis Galiotto, notary clerk, residing professionally at 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg, by
virtue of a proxy given on 12 August 2014;
- Ailita Systems Ltd., a company limited by shares organized and existing under the laws of the the British Virgin Islands,
with registered office at First Floor, Mandar House, Johnson’s Ghut, P.O. Box 3257, Road Town, Tortola, British Virgin
Islands and registered with the British Virgin Islands’ Registry of Corporate Affairs under the number 1767188;
here represented by Régis Galiotto, notary clerk, residing professionally at 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg, by
virtue of a proxy given on 12 August 2014.
Azeed Group Inc., Uline Commercial Inc., Ailita Systems Ltd. and Edenred Luxembourg S.A., prenamed, are being
referred to below as the Shareholders.
The Shareholders, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to record the following:
I. The Shareholders are the sole shareholders of Daripod Holding S.à r.l., a private limited liability company (“société
à responsabilité limitée”) governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 46a, avenue John F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, having a share capital of six million eight hundred seventy-eight thousand four hundred ten euro
(EUR 6,878,410), registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 185.028,
incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, prenamed, on 21 February 2014, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et des Associations number 1158 of 8 May 2014, amended for the last time pursuant to a deed
of Maître Henri Hellinckx, prenamed, on 18 June 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Asso-
ciations number 1929 of 24 July 2014 (the Company); the relevant proxies, after having been signed ne varietur by the
proxyholder of the respective appearing parties and the notary, shall remain attached to the present deed for the purpose
of registration.
II. The agenda of the meeting is the following:
1. Waiver of the convening notices;
2. Full restatement of the articles of association of the Company;
3. Management changes, consisting of the revocation of Uline Commercial Inc., the reassignment of the remaining
managers as B managers and C managers, and the appointment of Antoine Dumurgier, Arnaud Erulin and Péter Harbula
as A managers for a six years term;
4. Adoption of business plan; and
5. Miscellaneous.
These facts having been exposed and recognised as true by the meeting, the meeting unanimously requested the
undersigned notary to enact the following resolutions:
171199
L
U X E M B O U R G
<i>First resolutioni>
The Shareholders note that they represent the entire capital of the Company, so that the meeting can validly decide
on all the issues of the agenda, which are known to the Shareholders. The Shareholders resolve to waive any applicable
convening notices.
<i>Second resolutioni>
The meeting resolves to amend and restate the articles of association of the Company which shall henceforth be read
as follows:
1. Form and name. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name
Daripod Holding S.à r.l. (the Company), which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in
particular by the law dated August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), as well as by the present
articles of association (the Articles), as well as any shareholders’ agreement that may be entered into by and between
the shareholders of the Company from time to time (the Shareholders’ Agreement).
2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be
transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be, by the
board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand
Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders adopted
in the manner required for the amendment of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad
by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single
manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or
events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstan-
ces. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
3. Duration.
3.1. The Company is established for an unlimited period of time.
3.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,
bankruptcy or any similar event affecting one or several of the shareholders.
4. Corporate object.
4.1. The object of the Company is the acquisition of ownership interests, in Luxembourg or abroad, in any companies
or enterprises in any form whatsoever and the management of such ownership interests. The Company may in particular
acquire by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments
issued by any public or private entity whatsoever, including partnerships. It may participate in the creation, development,
management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a
portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever. This shall include without
limiting the scope of this provision:
- equity participation, by all means, in Dari Podarki, a limited liability company formed under the laws of the Russian
Federation, registered in the Unified State Register of Legal Entities under No. 1117746218699, the main activity of which
is the distribution of gift certificates either paper based, cards, evouchers or any other format in the Russian Federation
(Dari Podarki); and
- equity participation, by all means, in all companies or groups, having a similar or connected purpose to purpose of
Dari Podarki;
- short, medium and long-term financing and management of the funds of the companies it controls or that are under
the same control, including by entering into treasury, investment and hedging operations.
In order to carry out this purpose, the Company can resort, in any place, to all deeds and transactions, whatever their
nature and importance may be, and including through the setting up of new legal entities, to the subscription or purchase
of securities or corporate rights, the acquisition, the merger, as long as deeds and transactions contribute or can con-
tribute to, facilitate or can facilitate the implementation of the activities defined above, or as long as they allow the direct
or indirect safeguard of the commercial, industrial or financial interests of the Company, of its subsidiaries or of the
companies with which it has a business relationship.
4.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer in Luxembourg and abroad, in euros or other
currency. It may issue by way of private placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity
securities. The Company may lend funds in Luxembourg and abroad, in euros or other currency, including, without
limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies and/or
171200
L
U X E M B O U R G
to any other legal entity. It may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security
over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or obligations and undertakings
of any other legal entity and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any other legal entity or person.
4.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose
of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.
4.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect
to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.
5. Capital.
5.1. The Company's corporate capital is set at six million eight hundred seventy-eight thousand four hundred ten euro
(EUR 6,878,410) divided into six million eight hundred seventy-eight thousand four hundred ten (6,878,410) shares, with
a nominal value of one euro (EUR 1) each.
5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the
single shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for
the amendment of the Articles.
6. Shares.
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion
to the number of shares in existence.
6.2. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint
co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
6.3. Shares are freely transferable among shareholders or, if there is no more than one shareholder, to third parties.
In case of plurality of shareholders, the transfer of shares to nonshareholders is subject to the prior approval of the
general meeting of shareholders representing at least three quarters of the share capital of the Company.
A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,
the Company in accordance with article 1690 of the civil code.
For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4. A shareholders’ register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions
of the Law and may be examined by each shareholder who so requests.
7. Board of managers.
7.1. The board of managers of the Company shall consist of five (5) managers, three (3) of whom shall be appointed
among candidates designated by Edenred Luxembourg S.A. (the Class A Managers), one (1) of whom shall be appointed
among candidates designated by Azeed Group Inc. (the Class B Manager) and one (1) of whom shall be appointed among
candidates designated by Ailita Systems Ltd. (the Class C Manager). The members of the board of managers need not be
shareholder of the Company. Any manager shall be elected for a term not exceeding six years and shall be re-eligible.
7.2. In the event the percentage of shares jointly held by Azeed Group, Uline Commercial and Ailita Systems falls to
25% or less, the number of managers will be reduced to four (4): three (3) being the Class A Managers and one (1) being
the Class B Manager.
7.3. Whenever a legal entity is appointed as a manager of the Company (the Legal Entity), the Legal Entity must designate
a permanent representative to perform such manager’s mandate in its name and on its behalf (the Representative). The
Representative is subject to the same conditions and obligations, and incurs the same liability, as if he was performing
such manager’s mandate in his own name, without prejudice to the joint liability of the Legal Entity. The Legal Entity may
only revoke the Representative provided that it simultaneously appoints a new Representative.
7.4. The members of the board of managers shall be elected by the shareholder(s) of the Company at the general
meeting. Unless otherwise provided in the Shareholders’ Agreement, the shareholder(s) of the Company shall also de-
termine the number of managers, their remuneration and the term of their office. A manager may be removed with or
without cause and/or replaced, at any time, by resolution adopted by the general meeting of shareholders of the Company.
7.5. In the event of vacancy in the office of a manager because of death, retirement or otherwise, the remaining managers
may elect, by a majority vote, a manager to fill such vacancy until the next general meeting of shareholder(s) of the
Company.
8. Board meetings.
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall
within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of
managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s
object.
8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either shareholders
or not, by any manager of the Company, having obtained, as the case may be, the required prior approval under articles
16.3, 8.12 or 8.13.
171201
L
U X E M B O U R G
8.3. The board of managers of the Company shall appoint (i) a chairman among those of its managers designated by
Edenred as candidates for such function (the Chairman), and (ii) a vice-chairman among those of its managers designated
by Azeed Group as candidates for such function. If the Chairman for the time being is unable to attend any meeting of
the board of managers of the Company, the vice-chairman shall be appointed by the board as the ad hoc Chairman at
that meeting. The board of managers of the Company may choose a secretary, who need not be a manager, and who
shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers of the Company and the minutes
of the general meetings of the shareholders of the Company.
8.4. Each manager shall be entitled to one (1) vote. The chairman shall not have a casting vote.
8.5. The board of managers of the Company shall meet upon call by the chairman at the place indicated in the notice
of meeting which shall, in principle, be in Luxembourg.
8.6. Written notice of any meeting of the board of managers of the Company, issued in accordance with the provisions
of the Shareholders’ Agreement, shall be given to all managers at least ten (10) Business Days in advance of the date set
for such meeting, except if all managers agree in writing on a shorter period. Business Days means a day (other than
Saturday or Sunday) when banks are open for business in Luxembourg, British Virgin Islands, Moscow and Paris.
8.7. Unless otherwise stated in the Shareholders’ Agreement, no such written notice is required if all the members of
the board of managers of the Company are present or represented during the meeting and if they state to have been
duly informed, and to have had full knowledge of the agenda, of the meeting. The written notice may be waived by the
consent in writing, whether in original, by telefax or cable, of each member of the board of managers of the Company.
Separate written notice shall not be required for meetings that are held at times and places prescribed in a schedule
previously adopted by resolution of the board of managers of the Company.
8.8. Any member of the board of managers of the Company may act at any meeting of the board of managers of the
Company by appointing, in writing whether in original, by telefax or cable, another manager as his or her proxy.
8.9. Any manager may participate in a meeting of the board of managers of the Company by conference call or similar
means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear and speak to each other
and properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.
8.10. Unless otherwise provided in the Shareholders’ Agreement, the board of managers of the Company can deliberate
and/or act validly only if the majority of the Company’s managers is present or represented at a meeting of the board of
managers of the Company. Decisions shall be taken according to the majority rules set out under articles 8.12 and 8.13.
8.11. Unless otherwise provided in the Shareholders’ Agreement and subject to article 9.2 below, resolutions signed
by all managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly convened and held. Such
signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by
letter, telefax or telex.
8.12. Subject to the terms of the Shareholders’ Agreement, the matters expressly reserved to the competence of the
general meeting of shareholders under the Law and the Shareholder Reserved Matters (as defined below), the following
matters shall not be carried out without the approval of four-fifths (4/5) of the managers’ votes, including the Class B
Managers (the Board Reserved Matters):
a. preparation and approval of the annual budget of the Company (save in respect of the matters set out in article 8.13
(a), which will be Chairman Reserved Matters);
b. any transactions involving expenses, investments or capital expenditure exceeding fifty thousand US Dollars (USD
50,000) per year, which are not within the ordinary course of business or have not been approved in the annual budget
of the Company.
c. strategic matters, to the extent that they do not fall within the authority of the Chairman, including, inter alia, the
launch of new products and/or services beyond the scope of the shareholders’ intentions in relation to the business or
the expansion of the products and/or services outside of the Russian Federation;
d. the entry into of any acquisition, joint venture, capitalistic partnership, consortium or other similar arrangement;
e. the entry into, or approval of any annual financial commitment or payment under, any intra-group agreement (or
series of connected agreements) where the annual commitment or payment by the Company or Dari Podarki to any of
the shareholders or their affiliates exceeds fifty thousand US Dollars (USD 50,000). This is subject to the exception that
any intra-group agreement (or series of connected agreements) involving an annual commitment or payment to Edenred
or any of its affiliates exceeding fifty thousand US Dollars (USD 50,000) may be entered into between: (i) Edenred or any
of its affiliates; and (ii) the Company and/or Dari Podarki, provided that in these circumstances the Class B Manager shall
have the right, acting reasonably, to require at the board meeting during which the annual budget of the Company is
approved, the exclusion of any impact above fifty thousand US Dollars (USD 50,000) under the conditions set out in the
Shareholders’ Agreement.
f. divestment of assets in excess of fifty thousand US Dollars (USD 50,000) per transaction (or series of inter-related
transactions);
g. the giving of any guarantee and/or issue of any security other than in the ordinary course of business and in excess
of twenty thousand US Dollars (USD 20,000);
h. proposals for approval by the general meeting of shareholders of the determination and payment of distributions;
171202
L
U X E M B O U R G
i. the approval of all decisions made in relation to Dari Podarkiat its general meeting of participants on:
i. the annual budget of Dari Podarki, which shall be prepared by the general manager of Dari Podarki, and any amend-
ment thereto (in the cases set out in the Shareholders’ Agreement);
ii. the dismissal of the new general manager of Dari Podarkion the basis of a disciplinary measure pursuant to the labour
legislation of the Russian Federation;
iii. any distribution of dividends by Dari Podarki to the Company, otherwise than in accordance with the Shareholders’
Agreement;
iv. any matters that are set out in the aforementioned Board Reserved Matters or Shareholder Reserved Matters,
which shall apply mutatis mutandis for the purpose of this article such that references to the Company are replaced with
references to Dari Podarki;
v. any transactions requiring a general meeting of participants approval under Russian law.
8.13. Subject to matters expressly reserved to the competence of the general meeting of shareholders under the Law,
the Shareholder Reserved Matters and Board Reserved Matters, all decisions, including the following list of matters, shall
be approved by the board of managers at a simple majority of managers’ votes, including the Chairman’s vote (the
Chairman Reserved Matters):
(a) the preparation and approval of the annual budget of the Company in respect of organisation and meetings of the
corporate and governance bodies, running costs and other costs and expenses resulting from the duly approved annual
budget of Dari Podarki;
(b) the approval of the staffing table of the Company, staff remuneration, as well as approval of all employment agree-
ments;
(c) the approval of the staffing table of Dari Podarki, staff remuneration, as well as approval of all employment agree-
ments;
(d) the approval of all decisions made in relation to Dari Podarki at its general meeting of participants on:
(i) annual budget of Dari Podarki, which shall be prepared by the general director of the latter, and any amendment
thereto (in cases set out in the Shareholders’ Agreement);
(ii) the determination and payment of Dari Podarki’s dividend distributions;
(iii) the appointment (subject to the procedure set out in the Shareholder’s Agreement), remuneration and removal
of Dari Podarki’s general director;
(iv) the appointment (subject to the procedure set out in the Shareholder’s Agreement), remuneration, removal and
replacement of the chief financial officer of Dari Podarki;
(v) the appointment (subject to the procedure set out in the Shareholder’s Agreement), remuneration, removal and
replacement of the business development director of Dari Podarki;
(vi) the staffing table of Dari Podarki, staff remuneration, as well as approval of all employment agreements made with
Dari Podarki;
(vii) any matter falling into the authorities of Dari Podarki’s general meeting of participants, which is not included in
the Board Reserved Matters;
(e) Any residuary matter, which is not included in the Board Reserved Matters or the Shareholders Reserved Matters.
8.14. In the event of the percentage of shares jointly held by Azeed Group, Uline Commercial and Ailita Systems falling
to 25% or less, the Board Reserved Matters decisions will be made by a simple majority of the managers, provided,
however, that the Board Reserved Matters listed in article 8.12 will be made by a simple majority of the managers but
including at all times the Class B Manager.
9. Minutes of the board meetings.
9.1. Subject to article 9.2 below, the minutes of any meeting of the board of managers of the Company shall be signed
by the chairman of the board of managers of the Company who presided at such meeting or by any two managers of the
Company, including the chairman.
9.2. All decisions made during a board meeting held by audio- or videoconference are confirmed by circular resolutions
in writing signed by all managers present in person or by proxy at such audio- or video-conference in accordance with
the provisions of the Shareholders’ Agreement. Also for the avoidance of doubt, any decision taken by the board of
managers of the Company may be taken by way of written circular resolution signed by the requisite majority of managers,
without the need to hold a formal board meeting.
9.3. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed
by the secretary (if any) or by any manager of the Company.
10. Powers of the board of managers. The board of managers of the Company is vested with the broadest powers to
perform or cause to be performed all acts of disposition and administration in the Company’s interest. All powers not
expressly reserved by the Law, by the Articles or by the Shareholders’ Agreement to the general meeting of shareholder
(s) of the Company fall within the competence of the board of managers.
171203
L
U X E M B O U R G
11. Delegation of powers. Unless otherwise provided in the Shareholders’ Agreement, the board of managers of the
Company is authorised to appoint a person, either manager or not, without the prior authorisation of the general meeting
of the shareholder(s) of the Company, for the purposes of performing specific functions at every level within the Company.
The board of managers may thus delegate its powers for the conduct of the daily management of the Company, to one
or more managers, who will be called managing managers.
12. Representation. The Company shall be bound towards third parties by the single signature of the chairman of the
board of managers of the Company or the joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory
power has been validly delegated in accordance with article 11 of these Articles.
13. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any
commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these
Articles as well as the applicable provisions of the Law.
14. Conflict of interests.
14.1. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or
invalidated by the fact that any one or more of the managers or officers of the Company is interested in, or is a manager,
associate, officer or employee of such other company or firm.
14.2. Any manager or officer of the Company who serves as manager, officer or employee of any company or firm
with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, solely by reason of such affiliation with
such other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such
contract or other business.
14.3. In the event that any manager of the Company may have any personal and opposite interest in any transaction
of the Company, such manager shall make known to the board of managers of the Company such personal and opposite
interest and shall not consider or vote upon any such transaction, and such transaction, and such manager’s interest
therein, shall be reported to the next following general meeting of the shareholder(s) of the Company which shall ack-
nowledge such transaction.
14.4. In case there is only one shareholder in the Company, article 14.3. does not apply and the transactions that are
entered into between the Company and the manager having an opposite interest to the one of the Company are simply
to be recorded in minutes.
14.5. Articles 14.3. and 14.4. do not apply when the relevant transactions/operations are made in the normal course
of business of the Company and are entered into on arm’s length terms.
15. Powers and voting rights.
15.1. The single shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders.
15.2. Each shareholder has voting rights commensurate to its shareholding.
15.3. Each shareholder may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter,
telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of shareholders.
16. Form - Quorum - Majority.
16.1. If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular
resolution, the text of which shall be sent to all the shareholders in writing, whether in original or by telegram, telex,
facsimile or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the share-
holders may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter
or facsimile.
16.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of
the share capital.
16.3. However, the following Shareholder Reserved Matters shall not be carried out by the Company without the
specific approval of all shareholders at a general meeting of shareholders:
a. altering in any respect the Articles or the rights attaching to any of the shares;
b. the approval of the Company’s annual accounts and reports;
c. increasing the amount of the Company's issued share capital, granting any option or other interest (in the form of
convertible securities or in any other form) over or in its share capital, redeeming or purchasing any of its own shares
or effecting any other reorganisation of its share capital;
d. passing any resolution for its winding up or presenting any petition for its administration other than in accordance
with these Articles or the Shareholders’ Agreement (unless it has become insolvent);
e. the dissolution or demerger of the Company;
f. any sale, purchase, amalgamation or merger with any company or business undertaking (including for the avoidance
of doubt, any sale or purchase of Dari Podarki);
g. the determination and payment of distributions made in accordance with the Shareholders’ Agreement;
h. the appointment and removal of managers;
171204
L
U X E M B O U R G
i. changing the financial year of the Company; and
j. approving any amendments to a business plan which may from time to time be agreed upon between the shareholders
of the Company, and as the case may be set out in the Shareholders’ Agreement.
17. Accounting year.
17.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of July of each year and end on the thirtieth June of
each year.
17.2. Each year, with reference to the end of the Company’s accounting year, the Company’s accounts are established
and the manager or, in case there is a plurality of managers, the board of managers shall prepare an inventory including
an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.
17.3. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
18. Allocation of profits.
18.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation
and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated
to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share capital.
18.2. The general meeting of shareholders has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular
allocate such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.
18.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the manager or the board of managers;
(ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient funds are available for distribution; it being
understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year,
increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to the statutory reserve;
(iii) the decision to pay interim dividends is taken by the sole shareholder or the general meeting of shareholders;
(iv) assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened.
19. Dissolution - Liquidation.
19.1. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
who do not need to be shareholders, appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of
shareholders which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of
the shareholder(s) or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets
and payments of the liabilities of the Company.
19.2. The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be
paid to the shareholder or, in the case of a plurality of shareholders, the shareholders in proportion to the shares held
by each shareholder in the Company.
20. Applicable law. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the
Law.
<i>Third resolutioni>
The meeting resolves the following changes to the management of the Company:
(i) revocation of Uline Commercial Inc. as manager of the Company;
(ii) reassignment of the remaining managers Azeed Group Inc. and Ailita Systems Ltd, prenamed, respectively as B
managers and C managers of the Company;
(iii) appointment as A managers of the Company for a six years term:
(1) Antoine Dumurgier, Directeur Général Stratégie et Développement at Edenred France, born on 13 November
1973 in Paris 14, France, residing professionnally at Immeuble Columbus 166-180, boulevard Gabriel Péri 92245 Malakoff
cedex;
(2) Arnaud Erulin, Directeur zone Europe Centrale & Scandinavie at Edenred France, born on 9 June 1970 in Paris 16,
France, residing professionnally at Immeuble Columbus 166-180, boulevard Gabriel Péri 92245 Malakoff cedex;
(3) Péter Harbula, Directeur Exécutif Corporate Finance at Edenred France, born on 4 February 1975 in Budapest,
Hungaria, residing professionnally at Immeuble Columbus 166-180, boulevard Gabriel Péri 92245 Malakoff cedex;
<i>Fourth resolutioni>
The meeting resolves to adopt the business plan of the Company. Said business plan, after having been signed “ne
varietur” by the proxy acting on behalf of the appearing parties and the undersigned notary, will remain attached to the
present deed in order to be registered with it. There being no further business, the meeting is closed.
171205
L
U X E M B O U R G
<i>Estimated costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this
deed are estimated at approximately two thousand Euros (2,000.- EUR).
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties
the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties, in case
of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, who is known to the notary by his
surname, first name, civil status and residence, said proxyholder signed together with Us, notary, this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille quatorze, le quatorzième jour du mois d’août,
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
ONT COMPARU:
Edenred Luxembourg S.A., une société anonyme constituée en vertu de et appliquant les lois du Luxembourg, ayant
son siège social au 46a, Avenue John F. Kennedy, 1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 42434;
ici représentée par Régis Galiotto, clerc de notaire, résidant professionnellement au 101, rue Cents, L-1319 Luxem-
bourg, en vertu d’une procuration donnée le 12 août 2014;
Azeed Group Inc., une société limitée par actions constituée en vertu de et appliquant les lois des Iles Vierges britan-
niques, ayant son siège social à Mandar House, 1
er
étage, Johnson’s Ghut, P.O. Box 3257, Road Town, Tortola, Iles
Vierges britanniques, et immatriculée auprès du Registre de l’Office des Sociétés des Iles Vierges britanniques sous le
numéro 1661134;
ici représentée par Régis Galiotto, clerc de notaire, résidant professionnellement au 101, rue Cents, L-1319 Luxem-
bourg, en vertu d’une procuration donnée le 12 août 2014;
Uline Commercial Inc., une société limitée par actions constitué en vertu de et appliquant les lois des Iles Vierges
britanniques, ayant son siège social à Geneva Place, Waterfront Drive, P.O. Box 3469, Road Town, Tortola, Iles Vierges
britanniques, et immatriculée auprès du Registre de l’Office des Sociétés des Iles Vierges britanniques sous le numéro
1585137;
ici représentée par Régis Galiotto, clerc de notaire, résidant professionnellement au 101, rue Cents, L-1319 Luxem-
bourg, en vertu d’une procuration donnée le 12 août 2014;
Ailita Systems Ltd., une société limitée par actions constituée en vertu de et appliquant les lois des Iles Vierges bri-
tanniques, ayant son siège social à Mandar House, 1
er
étage, Johnson’s Ghut, P.O. Box 3257, Road Town, Tortola, Iles
Vierges britanniques, et immatriculée auprès du Registre de l’Office des Sociétés des Iles Vierges britanniques sous le
numéro 1767188;
ici représentée par Régis Galiotto, clerc de notaire, résidant professionnellement au 101, rue Cents, L-1319 Luxem-
bourg, en vertu d’une procuration donnée le 12 août 2014.
Azeed Group Inc., Uline Commercial Inc., Ailita Systems Ltd. et Edenred Luxembourg S.A., précitées, sont désignées
ci-dessous comme les Associés.
Les Associés, représentés tel que cité précédemment, ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. Les Associés sont les seuls associés de Daripod Holding S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit
du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, ayant un
capital social de 6 millions huit cent soixante-dix-huit mille quatre cent dix euros (EUR 6.878.410), immatriculée auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 185.028, constituée en vertu d’un acte de
Maître Henri Hellinckx, précité, en date du 21 février 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations
numéro 1158 du 8 mai 2014, modifié pour la dernière fois en vertu d’un acte de Maître Henri Hellinckx, précité, en date
du 18 juin 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations numéro 1929 du 24 juillet 2014 (la
Société); les procurations correspondantes, après avoir été signées ne varietur par le mandataire de chaque partie com-
parante et le notaire instrumentant, resteront annexées aux présentes à des fins d’enregistrement.
II. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Renonciation aux avis de convocation;
2. Reformulation complète des statuts de la Société;
3. Changements au niveau de la gérance, consistant en la révocation d’Uline Commercial Inc., la réassignation des
gérants restants comme gérants B et gérants C, et la nomination d’Antoine Dumurgier, Arnaud Erulin et Péter Harbula
comme gérants A pour une période de six ans;
171206
L
U X E M B O U R G
4. Adoption d’un plan d’entreprise; et
5. Divers.
(A)
Ces points ayant été exposés et reconnus par l’assemblée, celle-ci a requis à l’unanimité le notaire instrumentant d’acter
les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les Associés notent qu'ils représentent l’entièreté du capital social de la Société, de sorte que l’assemblée peut vala-
blement décider de tous les points de l’ordre du jour, qui sont connus des Associés. Les Associés décident de renoncer
à tout avis de convocation applicable.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier et reformuler les statuts de la Société qui seront désormais lus comme suit:
1. Forme et dénomination. Il existe une société à responsabilité limitée sous le nom de Daripod Holding S.à r.l. (la
Société) qui est régie par le droit du Grand-Duché de Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales, telle que modifiée, (la «Loi») ainsi que par les présents statuts (les Statuts), et par tout pacte des
associés qui peut être conclu occasionnellement par et entre les associés de la Société (le Pacte des Associés).
2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est sis à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg. Il pourra être transféré dans les
limites de la commune suite à une résolution du gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance
de la Société. Le siège social peut par ailleurs être transféré en tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg par
une résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification
des Statuts.
2.2. Des succursales, des filiales ou d'autres bureaux peuvent être établis au Grand-Duché du Luxembourg ou à
l’étranger, par résolution du gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance de la Société. Si le
gérant unique ou le conseil de gérance de la Société considère que des événements politiques ou militaires extraordinaires
se sont produits ou qu'ils sont imminents et que ceux-ci seraient de nature à perturber le cours normal des activités de
la Société au sein même de son siège social, ou de nature à rendre la communication entre ledit bureau et les personnes
situées à l’étranger plus difficile, le siège social pourra être temporairement transféré à l’étranger jusqu'à la cessation
complète de ces circonstances extraordinaires. De telles mesures temporaires n'auront aucun impact sur la nationalité
de la Société qui, malgré le transfert provisoire de son siège social, demeurera une société de droit luxembourgeois.
3. Durée.
3.1. La Société est établie pour une durée indéterminée.
3.2. La Société ne sera pas dissoute en cas de décès, suspension de droits civils, incapacité, insolvabilité, faillite ou tout
autre événement ayant un impact sur un ou plusieurs des associés.
4. Objet social.
4.1. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans d’autres sociétés ou
entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir
par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation,
obligations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité
publique ou privée, y compris des partenariats. Elle pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le
contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de
brevets ou d’autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit. Cela comprend sans limiter
la portée de cette disposition:
- la prise de participation, par tous moyens, dans Dari Podarki, une société à responsabilité limitée constituée en vertu
des lois de la Fédération de Russie, immatriculée auprès du Registre d’Etat Unique des Personnes Morales sous le numéro
1117746218699, l’activité principale de celle-ci étant la distribution de certificats cadeaux soit sous format papier, cartes,
bons électroniques ou tout autre format dans la Fédération de Russie (Dari Podarki);
- la prise de participation, par tous moyens, dans toutes sociétés ou groupes, ayant un objectif similaire ou lié à l’objectif
de Dari Podarki; et
- un financement et une gestion à court, moyen et long terme des fonds des sociétés qu'elle contrôle ou qui se trouvent
sous le même contrôle, notamment en engageant des opérations de trésorerie, d’investissement et de couverture.
Pour réaliser cet objet, la Société peut recourir en tous lieux à tous actes ou opérations de quelque nature et impor-
tance qu'ils soient, et notamment par voie de création de nouvelles entités juridiques, à la souscription ou achat de titres
ou droits sociaux, l’acquisition, la fusion, tant que les actes et opérations contribuent ou peuvent contribuer à, facilitent
ou peuvent faciliter la mise en oeuvre des activités définies ci-dessus, ou tant qu'ils autorisent la sauvegarde directe ou
indirecte des intérêts commerciaux, industriels ou financiers de la Société, de ses filiales ou des sociétés avec lesquelles
elle entretient une relation d’affaires.
171207
L
U X E M B O U R G
4.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d’offre publique, au Luxembourg et à
l’étranger, en euros ou une autre devise. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l’émission d’actions
et obligations et d’autres titres représentatifs d’emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds au
Luxembourg et à l’étranger, en euros ou une autre devise, y compris et sans limitation, ceux résultant des emprunts et/
ou des émissions d’obligations, à ses filiales, sociétés affiliées ou à toute autre société. Elle peut également consentir des
garanties, nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et octroyer des sûretés sur tous ou partie des ses actifs
afin de garantir ses obligations et engagements ou les obligations et/ou engagements de toute autre personne morale et,
de manière générale, pour son propre bénéfice et/ou le bénéfice de toute autre entité ou personne.
4.3. La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en
vue d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques liés aux
crédits ainsi qu'aux fluctuations de change, de taux d’intérêt et autres risques.
4.4. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts
de propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social ou
s’y rapportent de manière directe ou indirecte.
5. Capital social.
5.1. Le capital social de la Société est fixé à six millions huit cent soixante-dix-huit mille quatre cent dix euros (EUR
6.878.410) représenté par six millions huit cent soixante-dix-huit mille quatre cent dix (6.878.410) parts sociales ayant
une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune.
5.2. Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois par décision de l’associé unique
ou, en cas de pluralité d’associés, par l’assemblée générale des associés, délibérant comme en matière de modification
des Statuts.
6. Parts sociales.
6.1. Chaque part sociale donne droit à son propriétaire à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion
directe avec le nombre des parts sociales existantes.
6.2. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.
Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
6.3. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d’associé unique, à des tiers.
En cas de pluralité d’associés, la cession de parts sociales à des non-associés n’est possible qu'avec l’agrément donné
en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.
La cession de parts sociales n’est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle ait été notifiée à la Société ou
acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l’article 1690 du code civil.
Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il
pourra être consulté par chaque associé qui le demande.
7. Conseil de gérance.
7.1. Le conseil de gérance de la Société sera constitué de cinq (5) gérants, trois (3) d’entre eux seront nommés parmi
des candidats désignés par Edenred Luxembourg S.A. (les Gérants de Classe A), un (1) d’entre eux sera nommé parmi
des candidats désignés par Azeed Group Inc. (le Gérant de Classe B) et un (1) d’entre eux sera nommé parmi des candidats
désignés par Ailita Systems Ltd. (le Gérant de Classe C). Les membres du conseil de gérance ne doivent pas nécessairement
être des associés de la Société. Tout gérant sera élu pour un mandat n’excédant pas six ans et sera rééligible.
7.2. Dans le cas où le pourcentage de parts sociales détenues conjointement par Azeed Group, Uline Commercial et
Ailita tombe à 25% ou moins, le nombre de gérants sera réduit à quatre (4): trois (3) d’entre eux étant les Gérants de
Classe A et un (1) étant le Gérant de Classe B.
7.3. Lorsqu'une personne morale est nommée en tant que gérant de la Société (la Personne Morale), la Personne
Morale doit désigner un représentant permanent pour exercer ce mandat de gérant en son nom et pour son compte (le
Représentant). Le Représentant est soumis aux mêmes conditions et obligations, et encourt la même responsabilité que
s’il exerçait ce mandat de gérant en son propre nom, sans préjudice de la responsabilité conjointe de la Personne Morale.
La Personne Morale peut uniquement révoquer le Représentant pour autant qu'il nomme simultanément un nouveau
Représentant.
7.4. Les membres du conseil de gérance seront élus par l’/les associé(s) de la Société lors de l’assemblée générale. Sauf
disposition contraire prévue par le Pacte des Associés, l’/les associé(s) de la Société détermineront aussi le nombre de
gérants, leur rémunération et la durée de leur mandat. Un gérant peut être révoqué avec ou sans motif et/ou remplacé,
à tout moment, par une résolution adoptée par l’assemblée générale des associés de la Société.
7.5. En cas de vacance du poste d’un gérant pour cause de décès, retraite ou autre raison, les gérants restant peuvent
élire, à la majorité des voix, un gérant afin de pourvoir au poste vacant jusqu'à la prochaine assemblée générale des associés
de la Société.
171208
L
U X E M B O U R G
8. Réunions du conseil de gérance.
8.1. Tous les pouvoirs non expressément prévus par la Loi ou les présents Statuts à l’assemblée générale des associés
relèvent de la compétence du gérant unique, ou, en cas de gestion de la Société par plus d’un gérant, du conseil de gérance
qui aura tous les pouvoirs pour accomplir et approuver tous actes et opérations conformes à l’objet social de la Société.
8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs gérants,
associés ou non, par tout gérant de la Société ayant obtenu, comme cela peut être le cas, l’approbation préalable exigée
en vertu des articles 16.3, 8.12 ou 8.13.
8.3. Le conseil de gérance de la Société nommera (i) un président parmi ses gérants désignés par Edenred comme
candidats à cette fonction (le Président), et (ii) un vice-président parmi ses gérants désignés par Azeed Group comme
candidats pour cette fonction. Si le Président à l’heure actuelle ne peut assister à toute assemblée du conseil de gérance
de la Société, le vice-président sera nommé par le conseil de gérance comme Président ad hoc lors de cette assemblée.
Le conseil de gérance de la Société peut élire un secrétaire, qui ne doit pas nécessairement être gérant, et qui sera en
charge de conserver les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance de la Société et les procès-verbaux des
assemblées générales des associés de la Société.
8.4. Chaque gérant aura droit à un (1) vote. Le Président n’aura pas de voix prépondérante.
8.5. Le conseil de gérance de la Société se réunira sur convocation du Président au lieu indiqué dans l’avis de convo-
cation qui, en principe, sera au Luxembourg.
8.6. Un avis de convocation écrit à toute réunion du conseil de gérance de la Société, émis conformément aux dispo-
sitions du Pacte des Associés, sera donné à tous les gérants au moins dix (10) Jours Ouvrables avant la date fixée pour
cette assemblée, sauf si tous les gérants conviennent par écrit d’une période plus courte. Jours Ouvrables signifient un
jour (autre que le samedi et le dimanche) où les banques sont ouvertes au Luxembourg, aux Iles Vierges britanniques, à
Moscou et Paris.
8.7. Sauf disposition contraire prévue dans le Pacte des Associés, un tel avis écrit n’est pas requis si tous les membres
du conseil de gérance de la Société sont présents ou représentés à l’assemblée et s’ils déclarent avoir été dûment informés
et avoir pleine connaissance de l’ordre du jour de l’assemblée. Il peut aussi être renoncé à la convocation avec l’accord
de chaque gérant de la Société donné par écrit, soit en original, par téléfax ou télégramme. Une notification écrite séparée
n’est pas requise pour les assemblées tenues aux heures et lieux indiqués sur une annexe précédemment approuvée par
décision du conseil de gérance de la Société.
8.8. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance de la Société en désignant par écrit,
soit en original, soit par téléfax ou télégramme, un autre gérant comme son mandataire.
8.9. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout
autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s’entendre, se parler et délibérer valablement. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une parti-
cipation en personne à la réunion.
8.10. Sauf disposition contraire prévue dans le Pacte des Associés, le conseil de gérance de la Société ne pourra
délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou représentée à une réunion du conseil de
gérance de la Société. Les décisions seront prises conformément aux règles de majorité énoncées aux articles 8.12 et
8.13.
8.11. Sauf disposition contraire prévue dans le Pacte des Associés et sous réserve de l’article 9.2 ci-dessous, les ré-
solutions signées par tous les gérants seront considérées comme valablement adoptées comme si une réunion du conseil
de gérance avait été valablement convoquée et tenue. Les signatures des gérants peuvent être apposées sur un document
unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par courrier, téléfax ou télex.
8.12. Sous réserve des dispositions prévues dans le Pacte des Associés, les sujets relevant expressément de la com-
pétence de l’assemblée générale des associés en vertu de la Loi et des Sujets Réservés au Conseil (tels que définis ci-
dessous), les sujets suivants ne seront pas approuvés sans l’accord des quatre-cinquièmes (4/5) des votes des gérants, y
compris les Gérants de Classe B (les Sujets Réservés au Conseil):
a. Préparation et approbation du budget annuel de la Société (sauf pour les sujets énoncés à l’article 8.13 (a), qui sont
des Sujets Réservés au Président);
b. Toutes transactions contenant des dépenses, investissements ou dépenses de capital excédant un montant de cin-
quante mille dollars des Etats-Unis (USD 50.000) par an, qui ne rentrent pas dans le cours normal des activités ou qui
n’ont pas été approuvées dans le budget annuel de la Société;
c. Sujets stratégiques, dans la mesure où ils ne relèvent pas de l’autorité du Président, y compris, entre autres, le
lancement de nouveaux produits et/ou services qui dépassent le cadre des intentions des associés liées aux activités ou
le développement de produits et/ou services en dehors de la Fédération de Russie;
d. L’implication dans toute acquisition, co-entreprise, partenariat capitaliste, consortium ou autre arrangement simi-
laire;
e. L’implication dans, ou approbation de tout engagement financier annuel ou paiement, tout accord intra-groupe (ou
séries d’accords liés) où l’engagement annuel ou le paiement par la Société ou Dari Podarki à l’un des associés ou leurs
sociétés affiliées excède cinquante mille dollars des Etats-Unis (USD 50.000). Ceci est soumis à l’exception du fait que
171209
L
U X E M B O U R G
tout accord intra-groupe (ou séries d’accords liés) impliquant un engagement annuel ou paiement à Edenred ou l’une de
ses sociétés affiliées excédant cinquante mille dollars des Etats-Unis (USD 50.000) peut être conclu entre: (i) Edenred ou
l’une de ses sociétés affiliées; et (ii) la Société et/ou Dari Podarki, pour autant que dans ces circonstances le Gérant de
Classe B ait le droit, en agissant raisonnablement, de demander, lors d’une réunion du conseil de gérance durant laquelle
le budget annuel de la Société est approuvé, l’exclusion de toute incidence au-delà d’un montant de cinquante mille dollars
des Etats-Unis (USD 50.000) conformément aux conditions prévues dans le Pacte des Associés.
f. La cession d’actifs dépassant cinquante mille dollars des Etats-Unis (USD 50.000) par transaction (ou séries de
transactions liées entre elles);
g. L’octroi de toute garantie et/ou émission de tout titre n’ayant pas lieu dans le cadre du déroulement normal des
activités et dépassant vingt mille dollars des Etats-Unis (USD 20.000);
h. Propositions soumises à l’assemblée générale des associés afin de déterminer et payer les distributions;
i. L’approbation de toutes les décisions prises concernant Dari Podarki lors de son assemblée générale des participants
sur les sujets suivants:
(i) Le budget annuel de Dari Podarki, qui sera préparé par son directeur général, ainsi que toutes les modifications qui
y sont apportées (dans les cas énoncés dans le Pacte des Associés);
(ii) Le licenciement du nouveau directeur général de Dari Podarki sur base d’une mesure disciplinaire en vertu de la
législation du travail de la Fédération de Russie;
(iii) Toute distribution de dividendes par Dari Podarki à la Société, réalisée autrement qu'en conformité avec le Pacte
des Associés;
(iv) Tous sujets cités dans les Sujets Réservés au Conseil et Sujets Réservés aux Associés susmentionnés, qui s’appli-
queront mutatis mutandis aux fins de cet article de sorte que les références à la Société soient remplacées par des
références à Dari Podarki;
(v) Toutes transactions exigeant l’accord de l’assemblée générale des participants en vertu du droit russe.
8.13. Sous réserve des sujets relevant expressément de la compétence de l’assemblée générale des associés confor-
mément à la Loi, les Sujets Réservés aux Associés et les Sujets Réservés au Conseil, toutes décisions, y compris la liste
de sujets suivants, seront approuvés par le conseil de gérance à la majorité simple des votes des gérants, y compris le
vote du Président (les Sujets Réservés au Président):
a. La préparation et l’approbation du budget annuel de la Société en ce qui concerne l’organisation et les réunions des
organes sociaux et des organes de gestion, frais de fonctionnement et autres frais et dépenses résultant du budget annuel
dûment approuvé de Dari Podarki;
b. L’approbation du tableau d’effectifs de la Société, de la rémunération du personnel ainsi que l’approbation de tous
les contrats de travail;
c. L’approbation du tableau d’effectifs de Dari Podarki, de la rémunération du personnel ainsi que l’approbation de
tous les contrats de travail;
d. L’approbation de toutes les décisions prises en rapport avec Dari Podarki lors de son assemblée générale des
participants sur les points suivants:
(i) Budget annuel de Dari Podarki, qui sera préparé par le directeur général de celle-ci, et toute modification y relative
(dans les cas prévus dans le Pacte des Associés);
(ii) La détermination et le paiement des distributions de dividendes de Dari Podarki;
(iii) La nomination (soumise à la procédure prévue dans le Pacte des Associés), rémunération, et révocation du di-
recteur général de Dari Podarki;
(iv) La nomination (soumise à la procédure prévue dans le Pacte des Associés), rémunération, révocation et rempla-
cement du directeur général financier de Dari Podarki;
(v) La nomination (soumise à la procédure prévue dans le Pacte des Associés), rémunération, révocation et rempla-
cement du directeur du développement commercial de Dari Podarki;
(vi) Le tableau d’effectifs de Dari Podarki, la rémunération du personnel ainsi que l’approbation de tous les contrats
de travail conclus avec Dari Podarki;
(vii) Tout sujet relevant de l’autorité de l’assemblée générale des participants de Dari Podarki, qui ne font pas partie
des Sujets Réservés au Conseil;
e. Tout sujet restant qui ne fait pas partie des Sujets Réservés au Conseil ou des Sujets Réservés aux Associés.
8.14. Dans le cas où le pourcentage de parts sociales conjointement détenues par Azeed Group, Uline Commercial
et Ailita Systems tombe à 25% ou moins, les décisions concernant les Sujets Réservés au Conseil seront prises à la simple
majorité des votes des gérants, pour autant que, cependant, les Sujets Réservés au Conseil listés à l’article 8.12 soient
votés à la simple majorité des votes des gérants mais comprenant à tout moment le vote du Gérant de Classe B.
171210
L
U X E M B O U R G
9. Procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.
9.1. En vertu de l’article 9.2 ci-dessous, les procès-verbaux de chaque réunion du conseil de gérance de la Société
seront signés par le président du conseil de gérance de la Société qui a présidé ladite réunion ou par tous deux gérants
de la Société, y compris le président.
9.2. Toutes les décisions prises lors d’une réunion du conseil tenue par audio- ou vidéo-conférence seront confirmées
par des résolutions circulaires écrites signées par tous les gérants présents physiquement ou représentés lors de ladite
audio- ou vidéo-conférence, conformément aux dispositions prévues dans le Pacte des Associés. Pour éviter toute am-
biguïté, toute décision prise par le conseil de gérance de la Société peut être prise au moyen d’une résolution circulaire
signée par la majorité requise des gérants, sans qu'une réunion du conseil soit formellement tenue.
9.3. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le secrétaire
(le cas échéant) ou par un gérant de la Société.
10. Pouvoirs du conseil de gérance. Le conseil de gérance de la Société est investi des pouvoirs les plus étendus pour
accomplir ou prendre les mesures nécessaires pour réaliser tous actes de disposition et administratifs dans l’intérêt de
la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi, les Statuts ou le Pacte des Associés à l’assemblée
générale des associés de la Société relèvent de la compétence du conseil de gérance.
11. Délégation de pouvoirs. Sauf disposition contraire prévue dans le Pacte des Associés, le conseil de gérance de la
Société est autorisé à nommer une personne, gérant ou non, sans l’autorisation préalable de l’assemblée générale des
associés de la Société, afin d’exécuter des missions spécifiques à tous les niveaux de la Société. Le conseil de gérance peut
ainsi déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs gérants qui prendront la dénomination de gérants-
délégués.
12. Représentation. La Société sera engagée, vis-à-vis des tiers par la signature individuelle du président du conseil de
gérance de la Société ou par la signature conjointe ou la signature individuelle de toutes personnes auxquelles un pouvoir
de signature a été valablement donné conformément à l’article 11 de ces Statuts.
13. Responsabilité des gérants. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle
relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
pris en conformité avec les Statuts et les dispositions applicables de la Loi.
14. Conflit d’intérêts.
14.1. Aucun contrat ou autre transaction conclu entre la Société et une quelconque autre société, entreprise ou firme
ne pourra être affecté ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs gérants ou fondés de pouvoir de la Société possède un
intérêt dans, ou est un gérant, associé, dirigeant ou employé de cette autre société ou firme.
14.2. Tout gérant ou dirigeant de la Société qui exerce les fonctions de gérant, dirigeant ou employé de toute société
ou firme avec laquelle la Société pourra conclure ou entretenir des relations d’affaires ne pourra, uniquement en raison
d’une telle relation avec ladite société ou firme, être empêché de délibérer ou de voter des questions concernant ladite
convention ou lesdites affaires.
14.3. Dans le cas où un gérant de la Société aurait un intérêt personnel et opposé dans une transaction de la Société,
ce gérant devra en informer le conseil de gérance de la Société et ne pourra pas délibérer et voter ladite transaction, et
cette transaction ainsi que l’intérêt du gérant y afférent seront reportés à la prochaine assemblée des associés de la Société
qui reconnaîtra cette transaction.
14.4. En cas d’associé unique de la Société, l’article 14.3 ne s’applique pas et les transactions conclues entre la Société
et le gérant ayant un intérêt personnel et opposé à celui de la Société seront simplement enregistrées dans le procès-
verbal.
14.5. Les articles 14.3 et 14.4 ne s’appliquent pas lorsque les transactions/opérations correspondantes sont réalisées
dans le déroulement normal des activités de la Société et sont conclues sans lien de dépendance.
15. Pouvoirs et droits de vote.
15.1. L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l’assemblée générale des associés.
15.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
15.3. Chaque associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par
écrit que ce soit par courrier, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique, une autre personne ou entité comme
mandataire.
16. Forme - Quorum - Majorité.
16.1. Lorsque le nombre d’associés n’excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises
par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex,
téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures
des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par
courrier ou téléfax.
171211
L
U X E M B O U R G
16.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés
détenant plus de la moitié du capital social.
16.3. Toutefois, les Sujets Réservés aux Associés suivants ne pourront être exécutés par la Société sans l’accord
spécifique de tous les associés lors d’une assemblée générale des associés:
a. modifier de quelque façon les Statuts ou les droits attachés à l’une des parts sociales;
b. l’approbation des comptes et rapports annuels de la Société;
c. augmenter le montant du capital souscrit de la Société, octroyer toute option ou intérêt (sous la forme de titres
convertibles ou toute autre forme) sur ou dans son capital social, échanger ou acheter toute part sociale ou effectuer
une quelconque réorganisation de son capital social;
d. adopter toute résolution pour sa dissolution ou présenter une requête pour sa gestion autrement qu'en vertu de
ces Statuts ou du Pacte des Associés (à moins qu'il ne soit devenu insolvable);
e. la dissolution ou la scission de la Société;
f. la vente, l’achat, la fusion ou l’unification avec une quelconque société ou toute activitée pratiquée (y compris, afin
d’éviter toute ambiguïté, la vente ou l’achat de Dari Podarki);
g. la détermination et le paiement des distributions réalisées conformément au Pacte des Associés;
h. la nomination et la révocation de gérants;
i. changement de l’exercice social de la Société; et
j. approbation de tous changements apportés au plan d’entreprise qui peuvent être approuvés entre les associés de la
Société, et, comme cela peut être le cas, énoncés dans le Pacte des Associés.
17. Exercice social.
17.1. L’exercice social de la Société commence le premier juillet de chaque année et se termine le trente juin de chaque
année.
17.2. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Sociétés sont arrêtés et le gérant ou, en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance prépare un bilan avec l’indication des valeurs actives et passives de la Société.
17.3. Chaque associé pourra examiner ledit bilan au siège social de la Société.
18. Affectation des bénéfice.
18.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements
et charges constituent le bénéfice net de la société. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la
Société qui sera affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de
la Société.
18.2. L’assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l’affectation du solde restant du bénéfice net
annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d’un dividende, l’affecter à la réserve ou le reporter.
18.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués, à tout moment, sous les conditions suivantes:
a. Un relevé de comptes ou un inventaire ou rapport est établi par le gérant ou le conseil de gérance;
b. Ce relevé de comptes, inventaire ou rapport indiquera que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution;
étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier
exercice social, augmenté par le bénéfice reporté et les réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et
sommes qui seront allouées à la réserve légale;
c. La décision de payer des dividendes intérimaires est prise par l’associé unique ou l’assemblée générale des associés;
d. Il est assuré que les droits des créditeurs de la Société ne sont pas menacés.
19. Dissolution - Liquidation.
19.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémuné-
ration. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution de ou des associé(s) ou par la loi, les liquidateurs seront investis
des pouvoirs les plus étendus qui leur sont confiés pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.
19.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera distribué
à l’associé ou, en cas de pluralité d’associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales détenues par
chacun d’eux dans la Société.
20. Loi applicable. Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, il est fait référence aux dispo-
sitions légales de la Loi.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée adopte les changements suivants relatifs à la gestion de la Société:
i. révocation de Uline Commercial Inc. en tant que gérant de la Société;
ii. réaffecttion des gérants restants Azeed Group Inc. et Ailita Systems Ltd., précités, respectivement comme gérants
de classe B et gérants de classe C de la Société;
171212
L
U X E M B O U R G
iii. nomination des personnes suivantes en tant que gérants de classe A de la Société pour un mandat d’une durée de
six ans:
(1) Antoine Dumurgier, Directeur Général Stratégie et Développement chez Edenred France, né le 13 novembre 1973
à Paris 14, France, résidant professionnellement à Immeuble Columbus 166-180, boulevard Gabriel Péri, 92245 Malakoff
cedex;
(2) Arnaud Erulin, Directeur zone Europe Centrale et Scandinavie chez Edenred France, né le 9 juin 1970 à Paris 16,
France, résidant professionnellement à Immeuble Columbus 166-180, boulevard Gabriel Péri, 92245 Malakoff cedex;
(3) Péter Harbula, Directeur Exécutif Finance d’Entreprise chez Edenred France, né le 4 février 1975 à Budapest,
Hongrie, résidant professionnellement à Immeuble Columbus 166-180, boulevard Gabriel Péri, 92245 Malakoff cedex.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide d’adopter le plan d’entreprise de la Société. Ce plan d’entreprise, après avoir été signées ne varietur
par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes à des fins d’enre-
gistrement.
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution est estimé à environ deux mille Euros (2.000.- EUR).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande des parties comparantes, le présent
acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; à la demande de ces mêmes parties comparantes et en
cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, qui est connu du notaire par
son nom, prénom état civil résidence, ledit mandataire a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 août 2014. Relation: LAC/2014/39268. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 3 novembre 2014.
Référence de publication: 2014169684/810.
(140193960) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2014.
ELDIJK Mineral Oil Transport Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6760 Grevenmacher, 23, rue de Muenschecker.
R.C.S. Luxembourg B 76.475.
LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugement rendu en date du 2 octobre 2014, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, la dissolution
et la liquidation de la société ELDIJK MINERAL OIL TRANSPORT SARL, en abrégé E.M.O.T. SARL, (RCS B76475), avec
siège social à L-6760 Grevenmacher, 23, rue de Muenschecker, de fait inconnue à cette adresse,
Le même jugement a nommé juge-commissaire Madame Anita LECUIT, Juge, et liquidateur Maître Jessica VALENTI,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 24 octobre 2014 au greffe de la sixième
chambre de ce Tribunal.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Me Jessica VALENTI
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2014167747/20.
(140191472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2014.
171213
L
U X E M B O U R G
Arcelormittal Foundation, Fondation.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 24-26, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg G 178.
<i>Annual accountsi>
<i>December 31, 2013i>
<i>Table of contentsi>
Page
REPORT OF THE REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
ANNUAL ACCOUNTS
- Balance sheet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
- Profit and loss account . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
- Notes to the annual accounts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-8
<i>Report of the réviseur d'entreprises agrééi>
Following our appointment, we have audited the accompanying annual accounts of ArcelorMittal Foundation (pre-
viously Arcelor Mittal Foundation), which comprise the balance sheet as of December 31, 2013 and the profit and loss
account for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.
Responsibility of the Board of Governors' for the annual accounts
The Board of Governors is responsible for the preparation and fair presentation of these annual accounts in accordance
with the Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation of the annual accounts. This respon-
sibility includes internal control relevant to the preparation and fair presentation of annual accounts that are free from
material misstatement, whether due to fraud or error.
Responsibility of the réviseur d'entreprises agréé
Our responsibility is to express an opinion on these annual accounts based on our audit. We conducted our audit in
accordance with International Standards on Auditing as adopted for Luxembourg by the Commission de Surveillance du
Secteur Financier. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to
obtain reasonable assurance whether the annual accounts are free from material misstatement.
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the annual
accounts. The procedures selected depend on the judgement of the réviseur d'entreprises agréé, including the assessment
of the risks of material misstatement of the annual accounts, whether due to fraud or error. In making those risk assess-
ments, the réviseur d'entreprises agréé considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation
of the annual accounts in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the
purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating
the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by the Board of
Governors, as well as evaluating the overall presentation of the annual accounts.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit
opinion.
Opinion
In our opinion, the annual accounts give a true and fair view of the financial position of ArcelorMittal Foundation
(previously Arcelor Mittal Foundation) as of December 31, 2013, and of the results of its operations for the year then
ended in accordance with the Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation of the annual
accounts.
October 10, 2014.
<i>For Deloitte Audit S.à r.l,
Cabinet de révision agréé
i>Vafa Moayed
<i>Réviseur d'entreprises agréé
i>Signature
<i>Partneri>
<i>Balance sheeti>
<i>December 31, 2013i>
<i>(expressed in EUR)i>
ASSETS
2013
2012
CURRENT ASSETS
Debtors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-
3.078
171214
L
U X E M B O U R G
Cash at bank, cash in postal cheque accounts, cheques and cash in hand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512.757 538.083
TOTAL CURRENT ASSETS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512.757 541.161
PREPAYMENTS (note 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40346
58.898
TOTAL ASSETS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553,103 600,059
LIABILITIES
CAPITAL AND RESERVES (note 3)
Subscribed capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500,000 500,000
Profit or loss brought forward . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.054
25.969
Profit or Joss for the financial year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.385
15.192
TOTAL CAPITAL AND RESERVES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513,439 541,161
DEFERRED INCOME (note 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39,664
58.898
TOTAL LIABILITIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553,103 600,059
<i>Profit and loss accounti>
<i>For the period ended December 31, 2013i>
<i>(expressed in EUR)i>
CHARGES (note 4)
2013
2012
Other operating charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165,361 1,299,308
Interest and other financial charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
408
3,720
Profit for the financial year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6,385
15,192
172,154 1,318,220
INCOME (note 5)
Other operating income . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172,152 1,318,138
Other interest and other financial income . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
82
172,154 1,318,220
The underling notes form an integral part of these annual accounts.
Note 1. General. ArcelorMittal Foundation, hereafter «the Foundation» was formed on April 23, 2007 within the
definition of a not for profit foundation as defined by Luxembourg law for an unlimited period of time. On November
30, 2011, «the Foundation» changed its company name from «Arcelor Mittal Foundation» to «ArcelorMittal Foundation».
The Foundation's registered office is established in Luxembourg at 24-26, boulevard d'Avranches.
The financial year of the Foundation runs from the January 1 to December 31 of each year.
The object of the Foundation is to promote and coordinate the policies of the ArcelorMittal Group in the following
domains: arts and culture, environment, education, sports, community development, health and science.
Note 2. Summary of significant accounting policies. General principles
The annual accounts have been prepared in accordance with generally accepted accounting principles and in accordance
with the laws and regulations in force in the Grand-Duchy of Luxembourg, Main valuation rules
Translation of currencies
The Foundation maintains its accounting records in euro (EUR) and its annual accounts are expressed in this currency.
The transactions made in a currency other than EUR are translated into EUR at the exchange rate prevailing at the
transaction date. Assets, other than fixed assets, and liabilities denominated in currencies other than the EUR are trans-
lated into EUR at the exchange rate prevailing at the balance sheet date. Realized losses and gains and unrealized losses
are taken into account in the profit and loss account.
Bearing of administration and administrative and operating costs
ArcelorMittal S.A. has committed to bear, directly or through its direct or indirect subsidiaries, through periodic
contributions, all of the Foundation's expenses, administrative, operating, or other, including those incurred by projects
to be enacted or supported, which cannot be covered by the Foundation's revenue.
Charges
Charges contracted and incurred directly by the Foundation are recorded in the profit and loss account in the relevant
period of use of the projects.
Income
Contributions receivable by the Foundation from the ArcelorMittal group in respect of the charges contracted and
incurred directly by the Foundation are recorded as income in the profit and loss account at the same rate as the charges
to which they relate.
Note 3. Own funds. Arcelor, Société Anonyme and Mittal Steel Company N.V., now merged into ArcelorMittal, Société
Anonyme, have provided the Foundation with an endowment of five hundred thousand euro (EUR 500.000), that has
been deposited in a bank account opened in the name of the Foundation at its incorporation.
171215
L
U X E M B O U R G
Note 4. Charges. During 2013, the Foundation has committed to fund a total of six projects over defined periods of
time.
Other operating charges comprise the expenditure incurred on these projects in relation to the year ending December
31, 2013. Amounts paid by the Foundation covering funding periods subsequent to December 31, 2013 are included
within prepayments and accrued income. Also included within other operating charges are one ad-hoc contributions
made in the context of emergency aid following natural disasters.
Interest and similar charges consists of bank charges incurred by the Foundation during the year.
Any other operating expenditure of the Foundation has been borne directly by the ArcelorMittal group at no charge
to the Foundation.
The Foundation does not have any employees.
Note 5. Income. Other operating income consists of the contributions received by the Foundation from the Arce-
lorMittal group in connection with the operating charges incurred by the Foundation on its projects and emergency aid
in relation to the year ending December 31, 2013. Amounts received by the Foundation covering funding periods sub-
sequent to December 31, 2013 are included within accruals and deferred income.
Other interest and similar income consists of interest earned by the Foundation on its bank balance.
During 2013, the Foundation did not receive any donations, subsidies, grants or legacies form third parties other than
the ArcelorMittal group.
Note 6. Commitments.
2013
EUR
2012
EUR
Funding commitments
At the beginning of the year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58,898
89,420
Additions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172,113 1,280,842
At the end of the year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231,011 1,370,262
Payments made in relation to:
- current period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132,449 1,221,944
- old periods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58,898
89,420
191,347 1,311,364
Unpaid commitments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39,664
58,898
As described in Note 2, the ArcelorMittal Group will bear the unpaid commitments as and when they fall due.
<i>Global projects & Initiatives 2013 & Budget 2014 (US$)i>
Projects & Global activities
2013
Actual
2014
Proposal
Comments
Habitat for Humanity &
Other NGOs . . . . . . . . . . . . .
80,000
75,000
2013: South Africa (50k), T&T (30k)
2014: Argentina (15k), Mexico (25k), Liberia (20k) Spain (15k)
Junior Achievement . . . . . . . . .
65,000
75,000 2013: France (18k), South Africa (18k), Ukraine (18k), Fees (11k)
2014: Macedonia (8k), South Africa (10k), Spain (10), Italy (10k),
Belgium (10k), Romania (15k). Fees (12k)
Bone Marrow Donation . . . . .
10,000
10,000 2013: Algeria, Romania, South Africa
2014: South Africa and Algeria
Educational Projects . . . . . . . .
20,000
0 2013: Mexico (20k)
Emergency Aid . . . . . . . . . . . .
0
0
Solidarity Holidays . . . . . . . . .
0 250,000 2014: Argentina, Bosnia, Brazil, Kazakhstan, Liberia, Mexico,
Poland, Romania, South Africa.
New Year E-Card Contest . . .
25,000
30,000
Cents For Thousands . . . . . . .
32,000
42,000
Total in USS . . . . . . . . . . . . . . 232,000 482,000
Référence de publication: 2014167620/160.
(140191836) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2014.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
171216
3V Participations Luxembourg S.A.
Accipiter Finance S.à r.l.
Apollinaire S.A.
Aqua Infrastructure
Arcelormittal Foundation
Aures Services S.A.
Azimut Europe
Azimut Group
Baby Company S.A.
Barika S.à r.l.
Blake S.à r.l.
Catalyst Buyout I S.à r.l.
CITRA IMMOBILIERE SARL
Cogalux S.A.
Conselio S.A.
Dahm Gaslog Luxembourg
Dakota Investments S.A.
Damrock S.A.
Daripod Holding S.à r.l.
Dentsply Benelux S.à r.l.
Dentsply S.à r.l.
Dictame II S.A.
ELDIJK Mineral Oil Transport Sàrl
Forêt Vierge S.A.
Gestron Services (Luxembourg) S.A.
Giveall2Charity, Luxembourg Branch
Hellas Telecommunications (Luxembourg) II
HSH Investment Holdings FSO S.à r.l.
Melody S.A.
Norden S.A.
oneOone communication S.A.
Orbit Fund Management S.à r.l.
PCM Holding S.à r.l.
Pfaudler Midco S.à r.l.
Philippe Schmit architects
Red Blue (France) Properties S.à r.l.
Regent Acquisitions S.à r.l.
Silver Sea Holdings S.A.
Thann International S.A.
The Swatch Group Re (Luxembourg) S.A.
TH Leo S.à r.l.
Triton Masterluxco 3 S.à r.l.
Umbrellastream S.à r.l.
Vania & Diana S.à r.l.
Wullmaart-Pommerlach S.A.
Xilco Holding S.à r.l.