logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 3468

20 novembre 2014

SOMMAIRE

Coveris Holdings S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

166427

Eifel Management S.à r.l. & Partners S.C.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

166453

Eifel S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

166453

Elite S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

166418

Epinay S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

166418

Epinay S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

166418

Eprec S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

166423

Eraulux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

166418

Esaf International Management  . . . . . . . . .

166418

Espirito Santo Industrial S.A. . . . . . . . . . . . .

166419

Esther Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

166419

Euro Capital Markets Luxemburg S.A.  . . .

166418

Europa (Lux) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

166425

Exportcars s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

166420

Faccino SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

166421

Fashion House Group S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

166422

Fiduciaire SMC Luxembourg, Société Civi-

le  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

166422

Financière Epeios S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

166421

Fintax  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

166423

Firstluxe S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

166423

Fiusari S.A. SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

166424

Fondation Alphonse WEICKER  . . . . . . . . .

166420

Fortum Finance Ireland Limited Luxem-

bourg Branch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

166421

Fosun Luxembourg Holdings S.à r.l.  . . . . .

166419

Free Record Shop Luxembourg S.à r.l.  . . .

166419

FR Horizon Topco Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . .

166424

Garden Consult  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

166420

Garden Properties S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

166425

Garibaldi Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

166424

Gemat Grue Service S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

166422

Gläsener Transports S. à r. l.  . . . . . . . . . . . .

166425

Global Indemnity (Luxembourg) S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

166425

Gopal S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

166424

Governance People S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

166426

Group La Perla Living S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

166426

Investec Asset Management Luxembourg

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

166436

I/O Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

166422

Kanvass Furniture S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

166459

La Cuisine de Pékin S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

166462

La Financière Montbrillant S.A.  . . . . . . . . .

166462

LCO1 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

166464

Lear International Operations . . . . . . . . . . .

166462

Liu-Lux S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

166463

Lux and Sole International S.A. . . . . . . . . . .

166463

Lux-Sutures S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

166463

Luxzelte S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

166463

Matolux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

166462

Monitchem Holdco 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

166463

NaturService S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

166464

Naxamber S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

166464

NetOTC Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

166464

New Landscape S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

166464

Odyssey Opportunities 17 S.à r.l.  . . . . . . . .

166421

Primos S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

166426

Profima S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

166426

Swiss Life Funds (Lux) Global Infrastructu-

re Opportunities S.C.A., SICAV-SIF  . . . .

166448

166417

L

U X E M B O U R G

Elite S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 15, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 153.791.

Par la présente je démissionne de mon poste de Gérant Technique avec effet immédiat.

Strassen, le 21 juin 2014.

Alain Van Kasteren.

Référence de publication: 2014165473/9.
(140188665) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2014.

Epinay S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 66.184.

Les comptes annuels au 31 août 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014165479/9.
(140188647) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2014.

Epinay S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 66.184.

Les comptes annuels au 31 août 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014165480/9.
(140188648) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2014.

Eraulux, Société Anonyme.

Siège social: L-9530 Wiltz, 24, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 112.990.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014165484/9.
(140188884) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2014.

Esaf International Management, Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 50.293.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014165486/9.
(140188919) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2014.

Euro Capital Markets Luxemburg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 141.863.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014165491/9.
(140188836) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2014.

166418

L

U X E M B O U R G

Espirito Santo Industrial S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 39.299.

Il résulte du procès-verbal d'une réunion du conseil d'Administration de la Société tenue par voie circulaire en date

du 1 

er

 août 2014 que M. Manuel Fernando MONIZ GALVAO ESPIRITO SANTO SILVA, Administrateur de sociétés, né

le 20 juillet 1958 à S. Sebastião da Pedreira, Lisbonne, Portugal, avec adresse professionnelle à 62, Rua de São Bernardo,
P-1200-826 Lisbonne, a été nommé par voie de cooptation à la fonction d'Administrateur de la Société, avec effet im-
médiat, en remplacement de M. Luis Filipe DIEGUES DOS SANTOS, démissionnaire.

Son mandat expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2015. Sa cooptation sera soumise

pour ratification à la prochaine Assemblée Générale des actionnaires.

Pour extrait conforme
SG AUDIT S.à r.l.

Référence de publication: 2014165489/16.
(140188771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2014.

Esther Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 135.149.

Le bilan au 31/12/2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20/10/2014.

Signature.

Référence de publication: 2014165490/10.
(140188803) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2014.

Fosun Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 177.840.

Par résolutions prises en date du 26 septembre 2014, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Nomination de Mélanie Wilkin, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L- 1882 Luxembourg, au

mandat de gérant de catégorie B, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée;

2. Acceptation de la démission de Yannick Poos, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L- 1882

Luxembourg de son mandat de gérant de catégorie B, avec effet immédiat;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 octobre 2014.

Référence de publication: 2014165502/15.
(140189264) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2014.

Free Record Shop Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4011 Luxembourg, 121, rue de l'Alzette.

R.C.S. Luxembourg B 56.432.

Il résulte des résolutions de l'associé unique de la Société en date du 23 octobre 2014 que le siège social de la Société

a été transféré du 14, rue de l'Alzette, L-4010 Luxembourg au 121, rue de l'Alzette, L-4011 Luxembourg avec effet
immédiat.

Le 24 octobre 2014.

Pour extrait conforme
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014165520/13.
(140188649) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2014.

166419

L

U X E M B O U R G

Exportcars s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9230 Diekirch, 18, route d'Ettelbruck.

R.C.S. Luxembourg B 149.175.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Windhof, le 24/10/2014.

Référence de publication: 2014165494/10.
(140188712) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2014.

Garden Consult, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9911 Troisvierges, 2, rue de Drinklange.

R.C.S. Luxembourg B 157.145.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signatures
<i>Gérant

Référence de publication: 2014165523/12.
(140188844) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2014.

Fondation Alphonse WEICKER, Fondation.

Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg G 46.

<i>Bilan au 31.12.2013 (en EUR)

ACTIF

PASSIF

AVOIRS EN BANQUE . . . . . . .

847 096,95

DOTATION INITIALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

185 920,14

PORTEFEUILLE - TITRES . . . . .

987 456,09

RESULTATS EXERCICES ANTERIEURS . . . . . . . 1 516 616,27
DETTES DIVERSES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

944.14

RESULTAT DE L'EXERCICE . . . . . . . . . . . . . . . .

131 072,49

1 834 553,04

1 834 553,04

<i>Compte de résultat au 31.12.2013 (en EUR)

DEBIT

CREDIT

FRAIS GENERAUX . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 249,65

REVENUS DIVERS . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81 103,49

DEPENSES EN RELATION AVEC
L'OBJET DE LA FONDATION . . . . . . . .

26 282,93

INTERETS RECUS SUR AVOIRS
EN BANQUE ET SUR
OBLIGATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 501,58

DONS DIVERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75 000,00

RESULTAT DE L'EXERCICE . . . . . . . . . . 131 072,49

161 605,07

161 605,07

<i>Budget de l'exercice 2014 (en EUR)

DEBIT

CREDIT

FRAIS GENERAUX . . . . . . . . . . . . . . . . .

12 000,00

INTERETS RECUS SUR AVOIRS
EN BANQUE ET SUR
OBLIGATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 000,00

DEPENSES EN RELATION AVEC
L'OBJET DE LA FONDATION . . . . . . . . 240 000,00

REVENUS DIVERS ET DONS
DIVERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95 000,00

RESULTAT DE L'EXERCICE . . . . . . . . . . 152 000,00

252 000,00

252 000,00

Référence de publication: 2014165498/32.
(140187685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2014.

166420

L

U X E M B O U R G

Financière Epeios S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 79, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 79.837.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014165510/9.
(140188413) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2014.

Fortum Finance Ireland Limited Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 171.853.

EXTRAIT

Il résulte de la résolution de l'actionnaire unique en date du 1 

er

 septembre 2014 que:

- Fortum Finance Ireland Limited Luxembourg Branch, révoque Monsieur Sami Nummela de sa qualité de gérant A

avec effet au 1 

er

 septembre 2014;

- Monsieur Peter Lundin, avec adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Luxembourg,

est nommé gérant A avec effet au 1 

er

 septembre 2014 et pour une durée indéterminée;

Le conseil de gérance sera donc composé comme suit:
- Charlotte Lahaije-Hultman, gérant A;
- Peter Lundin, gérant A;
- Taina Honkala, gérant B;
- Jouni Huttunen, gérant B.
Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 24 octobre 2014.

Référence de publication: 2014165500/20.
(140188489) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2014.

Faccino SA, Société Anonyme.

Siège social: L-2536 Luxembourg, 3, rue Sigefroi.

R.C.S. Luxembourg B 148.613.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FACCINO SA
Société Anonyme

Référence de publication: 2014165503/11.
(140188700) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2014.

Odyssey Opportunities 17 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 104.186,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 138.436.

La soussignée AUDITEX Sàrl, 3A, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, RCS Luxembourg B 91.559, dé-

missionne avec effet immédiat de son poste de commissaire aux comptes de la société HURO SPF S.A., 3A, boulevard
du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, RCS Luxembourg B 19.534.

Luxembourg, le 23 octobre 2014.

AUDITEX SARL
Laurent JACQUEMART
<i>Gérant

Référence de publication: 2014165570/14.
(140189198) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2014.

166421

L

U X E M B O U R G

Fashion House Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 156.924.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire des associés du 17 octobre 2014

1. Monsieur Claude Schroeder, demeurant professionnellement au 498, Route de Thionville, L-5886 Alzingen a été

nommé gérant A, à durée indéterminée, en remplacement de Monsieur Herbert Grossmann décédé le 17 juin 2014.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2014165504/11.
(140188431) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2014.

Fiduciaire SMC Luxembourg, Société Civile, Société Civile.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg E 3.934.

Suite à la cession des parts en date du 23 octobre 2014 et par décision unanime des associés l'article 6 des statuts de

la société civile Fiduciaire SMC Luxembourg, constituée par acte sous seing privé le 17 juillet 2008, publié au Mémorial
C no 2107 du 30 août 2008, est modifié comme suit:

6. Le capital social est fixé à 5.000,00 Euro (cinq mille), divisé en 100 parts (cent) de 50,00 Euro (cinquante) chacune,

attribuées comme suit:

Monsieur Gerhard Nellinger, soixante parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

Monsieur Valerio Ragazzoni, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

SMC Trust Office S.A., Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

100

Luxembourg, le 24 octobre 2014.

Pour extrait conforme et sincère

Référence de publication: 2014165509/18.
(140188501) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2014.

Gemat Grue Service S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5655 Mondorf-les-Bains, 2, Passage Bernard Simminger.

R.C.S. Luxembourg B 60.511.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014165541/9.
(140189061) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2014.

I/O Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 102.131.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associée unique en date du 16 octobre 2014

1. M. Byron C. CHERRY a démissionné de son mandat de gérant de catégorie A.
2. Mme Jamey Susan SEELY, administrateur de sociétés, née au Texas (Etats-Unis d'Amérique), le 28 juillet 1971,

demeurant professionnellement à CityWest Blvd, suite 400, 77042-2839 Houston, Texas (Etats-Unis d'Amérique), a été
nommée comme gérante de catégorie A pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 24.10.2014.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour I/O Luxembourg S.à r.l .
Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2014165571/16.
(140189212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2014.

166422

L

U X E M B O U R G

Fintax, Société Anonyme.

Siège social: L-9570 Wiltz, 4, rue des Tondeurs.

R.C.S. Luxembourg B 174.355.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014165512/9.
(140189119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2014.

Firstluxe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 49, rue Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 179.152.

EXTRAIT

Il résulte du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire réunie extraordinairement, tenue en date du 17 octobre

2014 que:

L'assemblée décide de nommer comme administrateurs B, avec entrée en fonction au 17 octobre 2014:
- La société de droit luxembourgeois BUYFI SA, constituée en date du 5 décembre 2013, établie et ayant son siège

social à L-1631 Luxembourg, 49, rue Glesener, immatriculée sous le numéro RCS B 183049, représentée par son admi-
nistrateur délégué Monsieur Bruno JOYEROT, né le 14 Août 1965 à Issoudun (France), demeurant Lieudit Le Prieuré à
86230 SERIGNY (France)

- Monsieur Frank CHRISTIAENS, né le 07.05.1968 à Tongres (Belgique), demeurant 54, Op der Sterz à L-5823 Fen-

tange.

L'assemblée nomme aux fonctions du commissaire aux comptes, Monsieur Richard GAUTHROT, né le 14 novembre

1960 à Nancy (France) demeurant 38, Op der Heed, L-1747 Luxembourg, avec effet au 17 octobre 2014.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Référence de publication: 2014165495/21.
(140188869) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2014.

Eprec S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 114.266.

<i>Extrait des décisions prises par les actionnaires en date du 29 juillet 2014

1. M. Juan Antonio GUTIERREZ HERNANDO a été reconduit dans ses mandats d'administrateur et de président du

conseil d'administration jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2019.

2. M. Jean Marcel MAAS a été reconduit dans ses mandats d'administrateur et de vice-président du conseil d'adminis-

tration jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2019.

3. M. Daniel GOMEZ GARCIA a été reconduit dans son mandat d'administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale

statutaire de 2019.

4. M. Ignacio Francisco MENCOS VALDES a été reconduit dans son mandat d'administrateur jusqu'à l'issue de l'as-

semblée générale statutaire de 2019.

5. M. Julio CAVESTANY CORSINI a été reconduit dans son mandat d'administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée

générale statutaire de 2019.

6. La société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à r.l. a été reconduite dans son mandat de commissaire jusqu'à

l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2019.

Luxembourg, le 24 octobre 2014.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour EPREC S.A.
Un mandataire

Référence de publication: 2014165482/24.
(140188452) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2014.

166423

L

U X E M B O U R G

Fiusari S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon Ier.

R.C.S. Luxembourg B 47.702.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014165513/10.
(140189051) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2014.

FR Horizon Topco Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.249.141.626,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 138.941.

<i>Extrait du contrat de cession de parts de la Société daté du 14 octobre 2014

En vertu de l'acte de transfert de parts, daté du 14 octobre 2014, FR Horizon Holding S. à r.l., a transféré 100% de

ses parts détenues dans la Société de la manière suivante:

-1.249.141.626 parts sociales d'une valeur de 1 Euro chacune, à la société CHC Group Limited, avec siège social à 190,

Elgin Avenue, KY- KY1-9005 George Town, Grand Cayman, Iles Caïmanes et enregistré auprès du registre de commerce
des Iles Caïmanes sous le numéro WK-213521;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 octobre 2014.

Sophie Zintzen
<i>Mandataire

Référence de publication: 2014165518/18.
(140188335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2014.

Gopal S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

R.C.S. Luxembourg B 162.960.

Les comptes annuels clos au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014165551/10.
(140188325) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2014.

Garibaldi Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.572.000,00.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 205, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 104.787.

EXTRAIT

En date du 30 juin 2010, l'associé unique de la société (la «Société») a résolu de changer sa forme juridique en société

en commandite par actions (S.C.A.) et de modifier sa dénomination en Garibaldi S.C.A.

La Société déclare également par le présent extrait que la nouvelle adresse de son associé unique, est la suivante: 205,

route d'Arlon L-1150 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 octobre 2014.

Garibaldi Holdings S.à r.l

Référence de publication: 2014165525/16.
(140189223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2014.

166424

L

U X E M B O U R G

Gläsener Transports S. à r. l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5450 Stadtbredimus, 7, Lauthegaass.

R.C.S. Luxembourg B 139.944.

Der Jahresabschluss auf den 31.12.2013 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014165527/9.
(140188326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2014.

Garden Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4040 Esch-sur-Alzette, 5, rue Xavier Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 163.174.

Les comptes annuels au 30 novembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme
Garden Properties S.à r.l.

Référence de publication: 2014165524/11.
(140188387) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2014.

Europa (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.229.000,00.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 131.077.

Par résolutions prises en date du 8 octobre 2014, les associés ont pris les décisions suivantes:
1. Nomination de Jens Höllermann, avec adresse professionnelle au 15, rue Jean-Pierre Brasseur, L- 1258 Luxembourg,

au mandat de gérant de catégorie B, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée;

2. Nomination de Simon Barnes, avec adresse professionnelle au 15, rue Jean-Pierre Brasseur, L- 1258 Luxembourg,

au mandat de gérant de catégorie B, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée;

3. Révocation de Luxembourg Corporation Company S.A., avec siège social au 20, rue de la Poste, L- 2346 Luxembourg,

de son mandat de gérant de catégorie B, avec effet immédiat;

4. Révocation d'Alexandra Petitjean, avec adresse professionnelle au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, de son

mandat de gérante de catégorie B, avec effet immédiat;

5. Révocation de Phil Williams, avec adresse professionnelle au 20, rue de la Poste, L- 2346 Luxembourg, de son mandat

de gérant de catégorie B, avec effet immédiat;

6. Révocation de Laetitia Ambrosi, avec adresse professionnelle au 717, Fifth Avenue, 26 

th

 Floor, 10022 New York,

Etats-Unis, de son mandat de gérant de catégorie B, avec effet immédiat;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 octobre 2015.

Référence de publication: 2014165455/23.
(140188354) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2014.

Global Indemnity (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1253 Luxembourg, 2A, rue Nicolas Bové.

R.C.S. Luxembourg B 152.752.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Global Indemnity (Luxembourg) S.àr.l.
Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2014165528/11.
(140188416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2014.

166425

L

U X E M B O U R G

Governance People S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5411 Canach, 13, rue Lenningen.

R.C.S. Luxembourg B 176.027.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 octobre 2014.

<i>Pour compte de Governance People S.A.
Fiduplan S.A.

Référence de publication: 2014165531/12.
(140188702) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2014.

Group La Perla Living S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 104.035.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Par jugement du 23 octobre 2014 le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,

après avoir entendu Madame le Juge commissaire Carole Besch en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public
en leurs conclusions a déclaré closes pour insuffisance d'actif les opérations de liquidation de la société à responsabilité
limitée Group La Perla Living s.à.r.l dont le siège social à L-1653 Luxembourg, 2 avenue Charles de Gaulle a été dénoncé
en date du 5 octobre 2010.

Le prédit jugement a mis les frais à charge du Trésor.

Pour extrait conforme
Anne Devin-Kessler
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2014165533/17.
(140187901) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2014.

Primos S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 155.219.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 21 octobre 2014

<i>Résolution

L'Assemblée Générale décide d'accepter la démission de Monsieur Jean-Daniel Cohen de son mandat d'Administrateur

de la Société avec effet au 21 octobre 2014.

Pour extrait
La Société

Référence de publication: 2014165835/13.
(140188789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2014.

Profima S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 152.852.

Les comptes au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

PROFIMA S.A.
Alexis DE BERNARDI / Jacopo ROSSI
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2014165836/12.
(140188658) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2014.

166426

L

U X E M B O U R G

Coveris Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 178.003.

and
Exopack Holdings 2 S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
Capital social: EUR 12.500,00
R.C.S. Luxembourg: B 178037
(the Absorbed Company 1)
And
Coveris Management S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
Capital social: GBP 616.209,00
R.C.S. Luxembourg: B 167036
(the Absorbed Company 2)
And
Eifel Management S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
Share capital: EUR 12,500.00
R.C.S. Luxembourg: B 160365
(the Absorbed Company 3)
And
Eifel S.à r.l. (f.k.a. Eifel Management S.à r.l. &amp; Partners S.C.A.)
Société à responsabilité limitée
5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
Share capital: EUR 665.305,00
R.C.S. Luxembourg: B 161131
(the Absorbed Company 4)
And
Copper Management S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
Share capital: EUR 12,500.00
R.C.S. Luxembourg: B 155946
(the Absorbed Company 5)
And
Copper S.à r.l. (f.k.a. Copper Management S.à r.l. &amp; Partners S.C.A.)
Société à responsabilité limitée
5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
Capital social: EUR 764.174,00
R.C.S. Luxembourg: B 156043
(the Absorbed Company 6)
And
Island Lux S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
Share capital: EUR 12,500.00
R.C.S. Luxembourg: B 154935
(the Absorbed Company 7)

166427

L

U X E M B O U R G

And
Island S.à r.l. (f.k.a. Island Lux S.à r.l. &amp; Partners S.C.A.)
Société à responsabilité limitée
5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
Share capital: EUR 3.449.572,00
R.C.S. Luxembourg: B 154930
(the Absorbed Company 8)
In the year two thousand and fourteen, on the fourteenth of the month of November,
Before Us, Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1) Coveris Holdings S.A., a joint stock company (société anonyme), having its registered office at 5, rue Guillaume

Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
under number B 178003, established and existing under the laws of Luxembourg pursuant to a deed of the undersigned
notary, of May 29, 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1886 of August 5,
2013, and whose articles of association have been last amended pursuant to a deed of the undersigned notary of December
31, 2013 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 518, of February 26, 2014 (the
Absorbing Company),

here represented by Ms. Sofia Da Chao Conde, employee, with professional address at 5, rue Zénon Bernard, L-4030

Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg (the Attorney), by virtue of a special power of attorney granted by the
board of directors of the Absorbing Company of November 13, 2014 (the Resolutions 1), and

2) Exopack Holdings 2 S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered

office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, having a subscribed and fully paid in
share capital of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12.500,00) represented by of twelve thousand five hundred
(12.500) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each, registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register under number B 178037, established and existing under the laws of Luxembourg pursuant to a deed of the
undersigned notary, of May 29, 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1876, of
August 3, 2013, and whose articles of association have never been amended since then (the Absorbed Company 1),

here represented by the Attorney by virtue of a special power of attorney granted by the board of managers of the

Absorbed Company 1 of November 13, 2014 (the Resolutions 2), and

3) Coveris Management S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered

office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, having a subscribed and fully paid in
share capital of six hundred sixteen thousand two hundred nine Pounds Sterling (GBP 616.209,00) represented by two
hundred ninety-five thousand six hundred thirty six (295.636) class A shares and three hundred twenty thousand five
hundred seventy-three (320.573) class B shares with a nominal value of one Pound Sterling (GBP 1,00) each, registered
with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 167036, established and existing under the laws
of Luxembourg pursuant to a deed of the undersigned notary, of February 7, 2011, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations number 890, of April 5, 2012, and whose articles of association have been last amended
pursuant to a deed of the undersigned notary, of December 31, 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et des Associations number 520, of February 26, 2014 (the Absorbed Company 2),

here represented by the Attorney by virtue of a special power of attorney granted by the board of managers of the

Absorbed Company 2 of November 13, 2014 (the Resolutions 3), and

4) Eifel Management S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered

office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, having a subscribed and fully paid in
share  capital  of  twelve  thousand  five  hundred  Euros  (EUR  12.500,00)  represented  by  twelve  thousand  five  hundred
(12.500) shares of one Euro (EUR 1,00) each, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under
number B 160365, established and existing under the laws of Luxembourg pursuant to a deed of the undersigned notary
of March 7, 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of July 4, 2011, number 1459, and
whose articles of association have been last amended pursuant to a deed of the undersigned notary, of December 28,
2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 584, of March 6, 2012, (the Absorbed
Company 3),

here represented by the Attorney by virtue of a special power of attorney granted by the board of managers of the

Absorbed Company 3 of November 13, 2014 (the Resolutions 4), and

5) Eifel S.à r.l. (f.k.a. Eifel Management S.à r.l. &amp; Partners S.C.A.), a private limited liability company (société à respon-

sabilité limitée), having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,
having a subscribed and fully paid in share capital of six hundred sixty-five thousand three hundred five Euros (EUR
665.305,00) represented by six hundred sixty-five thousand three hundred five (665.305) shares with a nominal value of
one Euro (EUR 1,00) each, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 161131,
established and existing under the laws of Luxembourg pursuant to a deed of the undersigned notary, dated March 7,

166428

L

U X E M B O U R G

2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1833 of August 10, 2011, and whose
articles of association have been last amended pursuant to a deed of the undersigned notary dated November 6, 2014,
not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Absorbed Company 4),

here represented by the Attorney by virtue of a special power of attorney granted by the board of managers of the

Absorbed Company 4 of November 13, 2014 (the Resolutions 5), and

6) Copper Management S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered

office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, having a subscribed and fully paid in
share  capital  of  twelve  thousand  five  hundred  Euros  (EUR  12.500,00)  represented  by  twelve  thousand  five  hundred
(12.500) shares of one Euro (EUR 1,00) each, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under
number B 155946, established and existing under the laws of Luxembourg pursuant to a deed of the undersigned notary,
of October 5, 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2462 of November 15,
2010, and whose articles of association have never amended since then (the Absorbed Company 5),

here represented by the Attorney by virtue of a special power of attorney granted by the board of managers of the

Absorbed 5 Company of November 13, 2014 (the Resolutions 6), and

7) Copper S.à r.l., (f.k.a. Copper Management S.à r.l. &amp; Partners S.C.A.) a private limited liability company (société à

responsabilité limitée), having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duchy of Lu-
xembourg, having a subscribed and fully paid in share capital of seven hundred sixty-four thousand one hundred seventy-
four Euros (EUR 764.174,00) represented by five hundred sixty-five thousand five hundred sixteen (565.516) class A
shares and one hundred ninety-eight thousand six hundred fifty-eight (198.658) class B shares with a nominal value of one
Euro (EUR 1,00) each, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 156043, esta-
blished and existing under the laws of Luxembourg pursuant to a deed of the undersigned notary, of October 5, 2010,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2515 of November 19, 2010, and whose articles
of association have been last amended pursuant to a deed of the undersigned notary of November 6, 2014, not yet
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Absorbed Company 6),

here represented by the Attorney by virtue of a special power of attorney granted by the board of managers of the

Absorbed Company 6 of November 13, 2014 (the Resolutions 7), and

8) Island Lux S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at

5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, having a subscribed and fully paid in share
capital of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12.500,00) represented by twelve thousand five hundred (12.500)
shares of one Euro (EUR 1,00) each, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B
154935, established and existing under the laws of Luxembourg pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary
residing in Luxembourg, of August 5, 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of October
1, 2010, number 2057, and whose articles of association have never been amended since then (the Absorbed Company
7),

here represented by the Attorney by virtue of a special power of attorney granted by the board of managers of the

Absorbed Company 7 of November 13, 2014 (the Resolutions 8), and

9) Island S.à r.l. (f.k.a. Island Lux S.à r.l. &amp; Partners S.C.A.), a private limited liability company (société à responsabilité

limitée), having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, having
a subscribed and fully paid in share capital of three million four hundred forty-nine thousand five hundred seventy-two
Euros (EUR 3.449.572,00) represented three million four hundred twenty-four thousand seventy-two (3.424.072) class
A shares and twenty-five thousand five hundred (25.500) class B shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 154930, established and existing under
the laws of Luxembourg pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, dated August 5,
2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2070, dated October 4, 2010, and whose
bylaws have been last amended by a deed of the undersigned notary of November 6, 2014, not yet published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Absorbed Company 8),

here represented by the Attorney by virtue of a special power of attorney granted by the board of managers of the

Absorbed Company 8 of November 13, 2014 (the Resolutions 9).

A copy of the Resolutions 1, the Resolutions 2, the Resolutions 3, the Resolutions 4, the Resolutions 5, the Resolutions

6, the Resolutions 7, the Resolutions 8 and the Resolutions 9 signed ne varietur by the Attorney and the undersigned
notary will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

The Absorbed Company 1, the Absorbed Company 2, the Absorbed Company 3, the Absorbed Company 4, the

Absorbed Company 5, the Absorbed Company 6, the Absorbed Company 7 and the Absorbed Company 8 are hereinafter
referred to together as the Absorbed Companies.

The Absorbing Company and the Absorbed Companies are hereafter together referred to as the Merging Companies.
The Merging Companies are subject to the law of August 10, 1915 on commercial companies, as subsequently amended

(the Law).

It is acknowledged that article 268 of the Law shall not be applicable with regard to any bondholders of any company

of the Coveris Group, a single consolidated packaging businesses group also comprising Kobusch group of companies,

166429

L

U X E M B O U R G

Paragon Print and Packaging group of companies, Britton group of companies, Exopack group of companies and PACCOR
group of companies, which the Merging Companies are part of, to the extent that all required consents have been obtained
pursuant to article 269 of the Law.

The Attorney, acting for the board of directors of the Absorbing Company and for the board of managers of each of

the Absorbed Companies, requested the notary to draw up the merger proposal (the Merger Proposal) in the following
way:

MERGER PROPOSAL

The Absorbing Company proposes to merge with the Absorbed Companies by way of absorption (the Merger), it

being understood that the surviving entity will be the Absorbing Company.

The Absorbing Company is the owner of all the shares representing the entire share capital and all voting rights of the

Absorbed Companies, and as such the Merger (as defined below) is subject to the specific provisions of article 278 of the
Law.

Since the Absorbing Company holds one hundred per-cent (100%) of the shares in issue of the Absorbed Companies

and to the extent all the conditions of article 279 of the Law are met, the approval of the Merger by the extraordinary
general meeting of shareholders of each of the Merging Companies will not be required.

The documents referred to in article 267, paragraph 1, a), b) and c) of the Law (i.e. the Merger Proposal, the annual

accounts and the annual reports of the Merging Companies for the last three financial years as well as an interim financial
situation as of October 31, 2014) will be available for a period of at least one month prior to the Effective Time (as defined
below) of the Merger for inspection by the shareholder of the Absorbing Company at the registered office of the Merging
Companies in accordance with article 279 (1) (b) of the Law.

It is specifically mentioned that:
- the Absorbed Company 4 will have, prior to the Effective Time of the Merger, absorbed itself Eifel Holdings S.à r.l.,

a private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 5, Rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, having a subscribed and fully paid in share capital of twelve thousand
five hundred Euro (EUR 12.500,00) represented by twelve thousand five hundred (12.500) shares, having a nominal value
of one Euro (EUR 1,00) each, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 163855,
established and existing under the laws of Luxembourg pursuant to a deed of the undersigned notary, dated September
30, 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2842, of November 22, 2011, and
whose articles of association have been last amended pursuant to a deed of the undersigned notary, of December 3, 2013,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations number 501, of February 25, 2014; and

- the Absorbed Company 6 will have, prior to the Effective Time of the Merger, absorbed itself Copper International

Holdings S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 5, Rue
Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, having a subscribed and fully paid in share capital of
fifty-nine million two hundred eighty-eight thousand nine hundred nine Euro (EUR 59.288.909,00) represented by repre-
sented by fifty-nine million two hundred eighty-eight thousand nine hundred nine (59.288.909) shares, having a nominal
value of one Euro (EUR 1,00) each, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B
166096, established and existing under the Luxembourg laws pursuant to a deed of the undersigned notary, of December
30, 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 483, of February 23, 2012, and whose
articles of association have been last amended pursuant to a deed of the undersigned notary, of December 3, 2013,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations number 479, of February 21, 2014.

For the avoidance of doubt, it is reminded that the effective time of the Merger (the Effective Time) shall be 11:59 P.M.

on the day falling one (1) month after the publication of this Merger Proposal in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations.

The Merger will become effective vis-à-vis third parties as from the publication in the Mémorial C of the notarial

certificate referred to in article 273 (1) of the Law.

Now therefore, it is agreed as follows:
1. On the Effective Time, the Absorbed Companies shall, pursuant to articles 257 et seq. of the Law, contribute to the

Absorbing Company all their assets and all their liabilities, without any restriction or limitation.

2. The Merger is based on the interim accounts as of October 31, 2014, 2014 of each of the Merging Companies.
3. As from the Effective Time, all assets and liabilities of the Absorbed Companies shall be deemed transferred to the

Absorbing Company.

The assets and liabilities, which are all transferred at their book value to the Absorbing Company on the Effective

Time, are evaluated per the interim accounts of the Absorbed Companies as of October 31, 2014.

4. Discharge shall be granted to the board of managers of each of the Absorbed Companies for the exercise of their

mandates until the Effective Time of the Merger.

5. As a result of the Merger, the Absorbed Companies shall cease to exist and all their shares in issue shall be cancelled.

The activities of the Absorbed Companies will be continued by the Absorbing Company.

166430

L

U X E M B O U R G

6. No particular advantage has been granted to the members of the board of directors of the Absorbing Company nor

to the members of the board of managers of each of the Absorbed Companies.

7. Neither of the Merging Companies has issued securities (other than its shares) entitling their holders to a right to

vote.

8. The shares of the Absorbed Companies are free of all liens and charges and not encumbered by any security or

beneficial right or the holder of such lien, charge, security, or be otherwise permitted under the relevant loan documents.

9. As the Absorbed Companies do not have any employees, the Merger will not have any effect on employment.
10. The Merger shall further be subject to the following terms and conditions:
a) the Absorbing Company shall acquire the assets contributed by the Absorbed Companies in the state in which they

are on the Effective Time, without any right of recourse against the Absorbed Companies on whatever grounds;

b) the Absorbed Companies guarantee to the Absorbing Company the existence of all receivables included in the

assets contributed but do not assume any liability as to the solvency of the debtors concerned;

c) the Absorbing Company shall subsequently to the Merger pay all taxes, contributions, duties and levies whether

ordinary or extraordinary, which are due or may become due with respect to the Absorbed Companies or the property
of the assets contributed;

d) the Absorbing Company shall carry out all agreements and obligations of whatever kind of the Absorbed Companies

such as these agreements and obligations exist on the Effective Time;

e) the Absorbing Company shall in particular carry out all agreements existing with the creditors of the Absorbed

Companies and the Absorbing Company shall be subrogated to all rights and obligations resulting therefrom, at its own
risks;

f) the rights and claims comprised in the assets of the Absorbed Companies shall be transferred to the Absorbing

Company with all securities, either in rem or personal, attached thereto. The Absorbing Company shall thus be subro-
gated, without any novation, to all rights, whether in rem or personal, of the Absorbed Companies with respect to all
assets and against all debtors without any exception;

g) the Absorbing Company shall assume all liabilities of any kind of the Absorbed Companies and it shall in particular

assume interest and principal on all debts and liabilities of any kind due by the Absorbed Companies;

h) the Absorbing Company hereby formally waives any rights of preference, mortgage and rescission, which it may

have against the Absorbed Companies as a result of the Absorbing Company assuming debts, charges and obligations of
the Absorbed Companies and it explicitly dispenses the keepers of mortgages with making such an entry ex officio upon
registration of this deed.

11. From an accounting point of view, the Merger shall be deemed to be effective as from the Effective Time.
12. The Absorbing Company shall itself carry out all formalities, including such announcements as are prescribed by

Law, which are necessary or useful to carry into effect the Merger and the transfer and assignment of the assets and
liabilities of the Absorbed Companies to the Absorbing Company. Insofar as required by Law or deemed necessary or
useful, appropriate transfer instruments shall be executed by the Merging Companies to effect the transfer of the assets
and liabilities contributed by the Absorbed Companies to the Absorbing Company.

13. All corporate documents, files and records of the Absorbed Companies shall be kept at the registered office of

the Absorbing Company for so long as the Law prescribes.

14. Insofar as not specifically provided herein, the Merging Companies refer to the Law.

<i>Formalities

The Absorbing Company:
- shall carry out all legal and publication formalities relating to the contributions made in relation to the Merger;
- shall take on the statements and necessary formalities relating to all relevant administration matters in order to put

all assets acquired in its name;

- shall carry out any formalities in order to render the transfer of goods and rights that it has received opposable to

third parties.

<i>Delivery of titles

At the definitive realisation of the Merger, the Absorbed Companies will give the Absorbing Company the originals of

all its incorporating documents and amending deeds, as well as the books of accounts and other accounting documents,
titles of ownership or documentary acts of ownership of any assets, the supporting documents of the operations carried
out, securities and contracts, archives, vouchers and any other documents relating to the assets and rights transferred.

<i>Fees and duties

Any charges, duties or fees owing as a result of the Merger will be met by the Absorbing Company.
If necessary, the Absorbing Company shall pay the taxes due by the Absorbed Companies on the capital and the profits,

for the fiscal years not yet taxed.

166431

L

U X E M B O U R G

<i>Choice of the domicile

For the execution of the present deed and any subsequent ones or minutes which may arise as a result, and for any

supporting documents or notifications, the registered office of the Absorbing Company is chosen as domicile.

<i>Powers

All the powers are given to the bearer of a certified copy of the present deed in order to carry out all formalities and

complete all statements, notifications, deposits, publications and other such matters.

In accordance with the provisions of article 271 (2) of the Law, the undersigned notary certifies the legality of the

present merger deed drawn up pursuant to articles 261 and 278 of the Law.

<i>Opposability toward third parties

For the purpose of opposability of the Merger toward third parties, all the powers are given to the Attorney and to

the undersigned notary in order to issue a statement in accordance with article 273 (1) of the Law, stating that the
conditions set forth under article 279 of the Law are met, and to proceed with the publication of said statement.

Whereof, the present notarised deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the day named at the beginning of this

document.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English text and the French translation, the English version will prevail.

After having read and interpreted the contents to the Attorney in a language he understands, the Attorney, known to

the Notary by his surname, first name, civil status and residence, has signed the present deed with the Notary.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le quatorze novembre,
Par-devant Nous, Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1) Coveris Holdings S.A., une société anonyme, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,

Grand-Duché du Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 178003, constituée sous les lois luxembourgeoises par acte du notaire soussigné, du 29 mai 2013, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1886 du 5 août 2013, et dont les statuts ont été modifiés pour
la dernière fois par acte du notaire soussigné du 31 décembre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations numéro 518 du 26 février 2014 (la Société Absorbante),

ici représentée par Mme Sofia Da Chao Conde, employée privée, ayant son adresse professionnelle au 5, rue Zénon

Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand-Duché du Luxembourg (le Mandataire), en vertu d'un mandat spécial accordé
par résolutions du conseil d'administration de la Société Absorbante en date du 13 novembre 2014 (les Résolutions 1),
et

2) Exopack Holdings 2 S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll,

L-1882 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, ayant un capital social entièrement libéré de douze mille cinq cents
Euros (EUR 12.500,00), représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro
(EUR 1,00) chacune, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
178037, constituée sous les lois luxembourgeoises par acte du notaire soussigné, du 29 mai 2013, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations numéro 1876 du 3 août 2013, et dont les statuts n'ont jamais été modifiés depuis
(la Société Absorbée 1),

ici représentée par le Mandataire en vertu d'un mandat spécial accordé par résolutions du conseil de gérance de la

Société Absorbée 1 en date du 13 novembre 2014 (les Résolutions 2), et

3) Coveris Management S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll,

L-1882 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, ayant un capital social entièrement libéré de six cent seize mille deux
cent  neuf  Livres  Sterling  (GBP  616.209,00),  représenté  par  deux  cent  quatre-vingt-quinze  mille  six  cent  trente-six
(295.636) parts sociales de classe A et trois cent vingt mille cinq cent soixante-treize (320.573) parts sociales de classe
B d'une valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP 1,00) chacune, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 167036, constituée sous les lois luxembourgeoises par acte du notaire sous-
signé, du 7 février 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 890 du 5 avril 2012, et dont
les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire soussigné, du 31 décembre 2013, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 520 du 26 février 2014 (la Société Absorbée 2),

ici représentée par le Mandataire en vertu d'un mandat spécial accordé par résolutions du conseil de gérance de la

Société Absorbée 2 en date du 13 novembre 2014 (les Résolutions 3), et

4) Eifel Management S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882

Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social entièrement libéré de douze mille cinq cents Euros
(EUR 12.500,00) représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro (EUR

166432

L

U X E M B O U R G

1,00) chacune, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 160365,
constituée sous les lois luxembourgeoises par acte du notaire soussigné, du 7 mars 2011, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations numéro 1459 du 4 juillet 2011, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par
acte du notaire soussigné, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, du 28 décembre, 2011, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations numéro 584, du 6 mars 2012 (la Société Absorbée 3),

ici représentée par le Mandataire en vertu d'un mandat spécial accordé par résolutions du conseil de gérance de la

Société Absorbée 3 en date du 13 novembre 2014 (les Résolutions 4), et

5) Eifel S.à r.l. (anciennement dénommée Eifel Management S.à r.l. &amp; Partners S.C.A.), une société à responsabilité

limitée, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, ayant un
capital social entièrement libéré de six cent soixante-cinq mille trois cent cinq Euros (EUR 665.305,00) représenté par
six cent soixante-cinq mille trois cent cinq (665.305) parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune,
enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 161131,

constituée sous les lois luxembourgeoises par acte du notaire soussigné, du 7 mars 2011, publié au Mémorial C, Recueil

des Sociétés et Associations numéro 1833 du 10 août 2011, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par
acte du notaire soussigné du 6 novembre 2014, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
(la Société Absorbée 4),

ici représentée par le Mandataire en vertu d'un mandat spécial accordé par résolutions du conseil de gérance de la

Société Absorbée 4 en date 13 novembre 2014 (les Résolutions 5), et

6) Copper Management S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll,

L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social entièrement libéré de douze mille cinq cents
Euros (EUR 12.500,00) représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro
(EUR 1,00) chacune, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
155946, constituée sous les lois luxembourgeoises par acte du notaire soussigné, du 5 octobre 2010, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2462 du 15 novembre 2011, et dont les statuts n'ont jamais été modifiés
depuis (la Société Absorbée 5),

ici représentée par le Mandataire en vertu d'un mandat spécial accordé par résolutions du conseil de gérance de la

Société Absorbée 5 en date du 13 novembre 2014 (les Résolutions 6), et

7) Copper S.à r.l. (anciennement dénommée Copper Management S.à r.l. &amp; Partners S.C.A.), une société à responsa-

bilité limitée, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, ayant
un capital social entièrement libéré de sept cent soixante-quatre mille cent soixante-quatorze Euros (EUR 764.174,00)
représenté par cinq cent soixante-cinq mille cinq cent seize (565.516) parts sociales de classe A et cent quatre-vingt-dix-
huit mille six cent cinquante-huit (198.658) parts sociales de classe B d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune,
enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 156043, constituée sous
les lois luxembourgeoises par acte du notaire soussigné, du 5 octobre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations numéro 2515 du 19 novembre 2010, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un acte
du notaire soussigné du 6 novembre 2014, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (la
Société Absorbée 6),

ici représentée par le Mandataire en vertu d'un mandat spécial accordé par résolutions du conseil de gérance de la

Société Absorbée 6 en date du 13 novembre 2014 (les Résolutions 7), et

8) Island Lux S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882

Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social entièrement libéré de douze mille cinq cents Euros
(EUR 12.500,00) représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro (EUR
1,00) chacune, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 154935,
constituée sous les lois luxembourgeoises par acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, du 5
août 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2057 du 1er octobre 2010, et dont les
statuts n'ont jamais été modifiés depuis (la Société Absorbée 7),

ici représentée par le Mandataire en vertu d'un mandat spécial accordé par résolutions du conseil de gérance de la

Société Absorbée 7 en date du 13 novembre 2014 (les Résolutions 8), et

9) Island S.à r.l. (anciennement dénommée Island Lux S.à r.l. &amp; Partners S.C.A.), une société à responsabilité limitée,

ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital
social  entièrement  libéré  de  trois  millions  quatre  cent  quarante-neuf  mille  cinq  cent  soixante-douze  Euros  (EUR
3.449.572,00) représenté par trois millions quatre cent vingt-quatre mille soixante-douze (3.424.072) parts sociales de
classe A et vingt-cinq mille cinq-cents (25.500) parts sociales de classe B d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00)
chacune, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 154930, con-
stituée sous les lois luxembourgeoises par acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, du 5 août
2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2070 du 4 octobre 2010, et dont les statuts
ont été modifiés pour la dernière fois par un acte du notaire soussigné du 6 novembre 2014 non encore publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations (la Société Absorbée 8),

ici représentée par le Mandataire en vertu d'un mandat spécial accordé par résolutions du conseil de gérance de la

Société Absorbée 8 en date du 13 novembre 2014 (les Résolutions 9).

166433

L

U X E M B O U R G

Une copie des Résolutions 1, des Résolutions 2, des Résolutions 3, des Résolutions 4, des Résolutions 5, des Résolu-

tions 6, des Résolutions 7, des Résolutions 8 et des Résolutions 9 signées ne varietur par le Mandataire et le notaire
soussigné resteront annexées au présent acte en vue de leur dépôt auprès des autorités d'enregistrement.

La Société Absorbée 1, la Société Absorbée 2, la Société Absorbée 3, la Société Absorbée 4, la Société Absorbée 5,

la Société Absorbée 6, la Société Absorbée 7 et la Société Absorbée 8 sont ensemble désignées ci-après comme les
Sociétés Absorbées.

La Société Absorbante et les Sociétés Absorbées sont ensemble désignées ci-après comme les Sociétés Fusionnant.
Les Sociétés Fusionnant sont soumises à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée

(la Loi).

Il est reconnu que l'article 268 de la Loi ne sera pas applicable à l'égard de tout porteur d'obligations de toute société

du groupe Coveris, un groupe consolidé de sociétés d'emballage comprenant les groupes Kobusch, Paragon Print and
Packaging, Britton, Exopack et PACCOR, dont les Sociétés Fusionnant font partie, dans la mesure où tous les consente-
ments requis ont été obtenus conformément à l'article 269 de la Loi.

Le Mandataire, agissant pour le conseil d'administration de la Société Absorbante et pour le conseil de gérance de

chacune des Sociétés Absorbées, a requis le notaire instrumentant d'acter le projet de fusion (le Projet de Fusion) qui
suit:

PROJET DE FUSION

La Société Absorbante propose de fusionner avec les Sociétés Absorbées par voie d'absorption (la Fusion), étant

entendu que la société survivante sera la Société Absorbante.

La Société Absorbante est propriétaire de toutes les parts représentant l'intégralité du capital social et tous les droits

de vote des Sociétés Absorbées, en conséquence la Fusion (telle que définie ci-dessous) est soumise aux conditions
prévues à l'article 278 de la Loi.

Etant donné que la Société Absorbante détient cent pour-cent (100%) des parts émises par les Sociétés Absorbées et

dans la mesure où les conditions de l'article 279 de la Loi sont remplies, une approbation de la Fusion par l'assemblée
générale extraordinaire des associés de chacune des Sociétés Fusionnant ne sera pas requise.

Les documents mentionnés à l'article 267, paragraphe 1, a), b) et c) de la Loi (en l'occurrence le Projet de Fusion, les

comptes et rapports annuels des Sociétés Fusionnant pour les trois derniers exercices ainsi qu'un état comptable au 31
octobre 2014, seront disponibles pendant une période d'au moins un mois avant l'Heure d'Effet (telle que définit ci-
dessous) de la Fusion, pour inspection par les associés de la Société Absorbante au siège social des Sociétés Fusionnant,
conformément à l'article 279 (1) (b) de la Loi.

Il est expressément mentionné que:
- la Société Absorbée 4 aura, avant l'Heure d'Effet (telle que définit ci-dessous) de la Fusion, elle-même absorbé Eifel

Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
Grand-Duché du Luxembourg, ayant un capital social entièrement libéré de douze mille cinq cent Euro (EUR 12.500,00),
représenté par douze mille cinq cent (12.500) parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune, enre-
gistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 163855, constituée sous les
lois luxembourgeoises par acte du notaire soussigné, du 30 septembre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations numéro 2842 du 22 novembre 2011, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte
du notaire soussigné, du 3 décembre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 501 du
25 février 2014; et

- la Société Absorbée 6 aura, avant l'Heure d'Effet (telle que définit ci-dessous) de la Fusion, elle-même absorbé Copper

International Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882
Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, ayant un capital social entièrement libéré de cinquante-neuf millions deux
cent quatre-vingt-huit mille neuf cent neuf Euro (EUR 59.288.909,00), représenté par cinquante-neuf millions deux cent
quatre-vingt-huit mille neuf cent neuf (59.288.909) parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune,
enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 166096, constituée sous
les lois luxembourgeoises par acte du notaire soussigné, du 30 décembre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations numéro 483 du 23 février 2012, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un acte du
notaire soussigné, du 3 décembre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 479 du 21
février 2014.

Afin d'éviter tout doute, il est entendu que la Fusion produira ses effets à 23 heures 59, le jour tombant un (1) mois

après la publication de ce Projet de Fusion dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (l'Heure d'Effet).

La Fusion sera effective à l'égard des tiers à partir de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations

du certificat notarié dont il est question à l'article 273 (1) de la Loi au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Est arrêté ce qui suit:
1. A l'Heure d'Effet, les Sociétés Absorbées transmettront de manière universelle et sans limitation ni restriction tous

les éléments d'actif et de passif de leur patrimoine à la Société Absorbante, conformément aux articles 257 et suivants
de la Loi.

166434

L

U X E M B O U R G

2. La Fusion repose sur les comptes intérimaires du 31 octobre 2014 de chacune des Sociétés Fusionnant.
3. A compter de l'Heure d'Effet, l'universalité des éléments d'actif et de passif du patrimoine des Sociétés Absorbées

seront transférés à la Société Absorbante.

L'actif et le passif transférés à valeur comptable à la Société Absorbante à l'Heure d'Effet sont évalués suivant les

comptes intérimaires des Sociétés Absorbées au 31 octobre 2014.

4. Décharge sera accordée au conseil de gérance de chacune des Sociétés Absorbées pour l'exercice de leurs mandats

jusqu'à l'Heure d'Effet de la Fusion.

5. Par l'effet de la Fusion, les Sociétés Absorbées cesseront d'exister de plein droit et les parts sociales des Sociétés

Absorbées seront annulées. Les activités des Sociétés Absorbées seront reprises par la Société Absorbante.

6. Aucun avantage particulier n'a été consenti, ni aux membres du conseil d'administration de la Société Absorbante,

ni aux membres du conseil de gérance de chacune des Sociétés Absorbées.

7. Aucune des Sociétés Fusionnant n'a émis de titres (autres que des parts sociales) conférant à leur porteur un droit

de vote.

8. Les parts sociales des Sociétés Absorbées sont libres de toutes sûretés, privilèges et droit de rétention, ou sont par

ailleurs autorisés selon les contrats de prêts y afférant.

9. Les Sociétés Absorbées n'ayant pas d'employés, la Fusion restera sans conséquence sur l'emploi.
10. La Fusion est également soumise aux termes et conditions suivants:
a) la Société Absorbante reprend les actifs transférés par les Sociétés Absorbées en l'état dans lequel ils se trouvent

à l'Heure d'Effet sans aucune prétention, à quelque titre que ce soit, contre les Sociétés Absorbées;

b) les Sociétés Absorbées garantissent à la Société Absorbante l'existence de toutes les créances comprises dans les

actifs apportés, mais n'assumeront aucune responsabilité quant à la solvabilité des débiteurs concernés;

c) suite à la Fusion, la Société Absorbante payera tous les impôts, taxes et redevances, ordinaires et extraordinaires

qui pourront être exigés, eu égard des Sociétés Absorbées ou à la propriété des actifs transférés;

d) la Société Absorbante reprend l'intégralité des obligations et contrats des Sociétés Absorbées, tels qu'ils existent

à l'Heure d'Effet;

e) la Société Absorbante reprend en particulier l'intégralité des contrats existants avec les créanciers des Sociétés

Absorbées. La Société Absorbante sera subrogée dans tous les droits et obligations en découlant et ceci à ses propres
risques;

f) les droits et revendications sociales attachés aux actifs transférés par les Sociétés Absorbées seront transférés avec

l'intégralité des sûretés réelles et personnelles à la Société Absorbante. La Société Absorbante sera de ce fait subrogée,
sans qu'il n'y ait novation des contrats, dans tous les droits réels et personnels des Sociétés Absorbées, et ceci sans
exception pour tous les actifs et à l'égard de tous les débiteurs;

g) la Société Absorbante reprend l'intégralité des obligations des Sociétés Absorbées, et en particulier, la Société

Absorbante sera redevable des intérêts et du capital de toutes dettes et obligations des Sociétés Absorbées;

h) la Société Absorbante renonce expressément à tous droits de privilège, d'hypothèque et action résolutoire qu'elle

détient envers les Sociétés Absorbées, du fait de la reprise des droits et obligations de ces dernières, et dispense ex-
pressément le bureau des hypothèques d'effectuer cette inscription ex officio lors de l'enregistrement du présent acte.

11. D'un point de vue comptable, la Fusion produira ses effets à compter de l'Heure d'Effet.
12. La Société Absorbante peut accomplir toutes formalités, y compris les publications prévues par la Loi, utiles ou

nécessaires à l'entrée en vigueur de la Fusion ou servant la transmission des actifs et passifs. Si prévu par la Loi, ou lorsque
cela peut servir la transmission des actifs et passifs, les actes translatifs seront accomplis par les Sociétés Fusionnant afin
de garantir la transmission des actifs et passifs des Sociétés Absorbées vers la Société Absorbante.

13. Tout document, acte et registre des Sociétés Absorbées sera conservé au siège social de la Société Absorbante

pendant la durée prévue par la Loi.

14. Pour tout point non prévu par les présentes, les parties se réfèrent à la Loi.

<i>Formalités

La Société Absorbante:
- effectuera toutes les formalités légales et de publication relatives aux apports effectués au titre de la Fusion;
- se chargera de toutes déclarations et formalités nécessaires auprès de toutes administrations compétentes pour faire

mettre à son nom les éléments d'actif apportés;

- effectuera toutes les formalités en vue de rendre opposable aux tiers la transmission des biens et droits reçus.

<i>Remise de titres

Lors de la réalisation définitive de la Fusion, les Sociétés Absorbées remettront à la Société Absorbante les originaux

de tous ses documents constitutifs et modificatifs ainsi que les livres de comptabilité et autres documents comptables,
les titres de propriété ou actes justificatifs de propriété de tous les éléments d'actif, les justificatifs des opérations réalisées,

166435

L

U X E M B O U R G

les valeurs mobilières ainsi que tous contrats, archives, pièces et autres documents quelconques relatifs aux éléments et
droits apportés.

<i>Frais et droits

Tous frais, droits et honoraires dus au titre de la Fusion seront supportés par la Société Absorbante.
La Société Absorbante acquittera, le cas échéant, les impôts dus par les Sociétés Absorbées sur le capital et les bénéfices

au titre des exercices non encore imposés définitivement.

<i>Election de domicile

Pour l'exécution des présentes et des actes ou procès-verbaux qui en seront la suite ou la conséquence ainsi que pour

toutes justifications et notifications, il est fait élection de domicile au siège social de la Société Absorbante.

<i>Pouvoirs

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie certifiée des présentes pour effectuer toutes formalités et faire

toutes déclarations, significations, dépôts, publications et autres.

Conformément aux dispositions de l'article 271 (2) de la Loi, le notaire soussigné atteste de la légalité du présent

Projet de Fusion établi en application des articles 261 et 278 de la Loi.

<i>Opposabilité à l'égard des tiers

Aux fins d'opposabilité de la Fusion à l'égard des tiers, tous pouvoirs sont donnés au Mandataire et au notaire soussigné

pour émettre un certificat conformément à l'article 273 (1) de la Loi, constatant que les conditions de l'article 279 sont
remplies, et pour procéder à la publication dudit certificat.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.
Le notaire instrumentaire, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparantes, le

présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction française. Il est spécifié qu'en cas de divergences entre
la version anglaise et la traduction française, le texte anglais fera foi.

Après lecture faite au Mandataire et interprétation donnée en une langue de lui connue, le Mandataire, connu du

notaire instrumentant par ses nom, prénom, état et demeure, a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 14 novembre 2014. Relation: EAC/2014/15451. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2014178320/543.
(140204292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2014.

Investec Asset Management Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1160 Luxembourg, 32-36, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 162.485.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-second day of October,
Before us Maître Henri Hellinckx, notary of residence in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

was held

an extraordinary general meeting (the "Meeting") of the sole shareholder of Investec Asset Management Luxembourg

S.A., a public limited company (société anonyme) existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its
registered  office  at  32-36,  Boulevard  d’Avranches,  L-1160  Luxembourg,  registered  with  the  Luxembourg  Trade  and
Companies Register under number B 162.485 (the "Company"), incorporated under the name “SCOR Alternative In-
vestments S.A., Société Anonyme" pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, prenamed notary, on 8 July 2011,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 1802 of 8 August 2011. The articles of incorporation
were amended for the last time by a deed of Maître Henri Hellinckx, prenamed notary, on 30 April 2014 published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N°1272 of 19 May 2014.

The Meeting was opened at 2:30 pm with Mrs Michèle Kemp, Avocat à la Cour, residing professionally in Luxembourg,

in the chair.

The chairman appointed as secretary, Mrs Camille Delacoute, Lawyer, residing professionally in Luxembourg and

nominated as scrutineer, Mrs Fabienne Moreau, Jurist, residing professionally in Luxembourg.

The board of the Meeting having been constituted, the chairman declared and requested the notary to record:
I. The names of the shareholders present at the Meeting or duly represented by proxy, the proxies of the represented

shareholders, as well as the number of shares held by each shareholder, are set forth on an attendance list, signed by the

166436

L

U X E M B O U R G

shareholders present, the proxies of the represented shareholders, the members of the board of the Meeting and the
notary. The aforesaid list shall be attached to the present deed and registered therewith. The proxies given shall be
initialed ne varietur by the members of the board of the Meeting and by the notary and shall be attached in the same way
to this document.

II. That it appears from the attendance list, which shall remain attached to the present minutes to be filed therewith

with the registration authorities, that one hundred per cent (100%) of the shares of the Company are present or repre-
sented at the Meeting;

III. In accordance with the provisions of the articles of incorporation of the Company and article 67-1 (2) of the

Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, the quorum of at least one half of the share
capital of the Company is required and the resolution on each item of the agenda has to be passed by the affirmative vote
of at least two thirds of the votes validly cast at the Meeting.

IV. The whole corporate capital of the Company being present or represented at the present Meeting and all the

shareholders present or represented declaring that they had due notice and got knowledge of the agenda, the eight (8)
days prior notice have been waived.

V. The Meeting is regularly constituted and can validly deliberate and decide on all the items of the agenda as follows:

<i>Agenda

1. Amendment of article 3 of the articles of incorporation of the Company which shall henceforth read as follows:
“The object of the Company is the collective portfolio management of one or several Luxembourg and/or foreign

collective investment funds in transferable securities authorised according to Directive 2009/65/EC (as may be amended
from time to time) (“UCITS”) and of other Luxembourg and foreign collective investment funds not covered by this
Directive (“UCI”) (together, the “Funds”) on behalf of their unit-holders or shareholders in accordance with the provi-
sions of chapter 15 of the Luxembourg law of 17 December 2010 on undertakings for collective investment (as amended
from time to time) (the “2010 Law”).

The Company may also serve as advisor to the Funds in connection with the management of their assets and their

promotion/distribution.

The activity of collective portfolio management of the Funds includes the following functions:
- Investment Management. In this regard, the Company may, for the account of the Funds: (i) provide investment advice

and make investment decisions, (ii) enter into agreements, (iii) buy, sell, exchange and deliver any sort of transferable
securities and/or other acceptable types of assets, and (iv) exercise all voting rights pertaining to securities held by the
Funds under management. This enumeration is not exhaustive.

- Administration of Funds. This function includes all activities listed under “Administration” in Annex II of the 2010

Law i.e. namely (i) the valuation of the Funds’ portfolios and the pricing of the units/shares, (ii) the issue and redemption
of the units/shares of the Funds, (iii) the maintenance of units/shares holder registers, and (iv) the record keeping of
transactions. This enumeration is not exhaustive.

- Distribution and marketing of the units/shares of the Funds within and outside of Luxembourg.
The Company may perform part or all of these activities for any UCITS and/or UCI and/or any other management

companies as a delegate.

The Company may provide services within and outside of Luxembourg and may for that purpose establish represen-

tative offices and/or branches.

The Company may also administer its own assets on an ancillary basis and carry out any operations which it may deem

useful in the accomplishment and development of its purposes as well as any other activity authorised under all applicable
laws and in particular, under the law of 10 August 1915 on commercial companies (as amended from time to time) (the
"1915 Law") and Chapter 15 of the 2010 Law.”

2. Amendment of article 4 of the articles of incorporation of the Company which shall henceforth read as follows:
“The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, in the Grand Duchy of Luxembourg. Bran-

ches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

The registered office of the Company may be transferred by a decision of the board of directors provided that it

remains in Luxembourg-City.

In the event that the board of directors determines that extraordinary political or military developments have occurred

or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease
of communication between such office and persons in any other location, the registered office may be temporarily trans-
ferred outside of the Grand Duchy of Luxembourg until the complete cessation of these abnormal circumstances; such
temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer
of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such declaration of the transfer of the registered office shall
be made and brought to the attention of third parties by one of the executive organs of the Company which has powers
to commit the Company for acts of daily and ordinary management.”

3. Amendment of article 5 of the articles of incorporation of the Company which shall henceforth read as follows:

166437

L

U X E M B O U R G

“The subscribed capital of the Company is set at one hundred and twenty five thousand euro (EUR 125,000.-) repre-

sented by one thousand two hundred and fifty (1,250) ordinary shares, fully paid up, without nominal value.

A general meeting of shareholders, held in accordance with Luxembourg law, may approve the creation of other classes

of shares, notably the creation, by issuance or conversion, of shares without voting rights but benefiting from other
preferred rights.

The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of a general meeting of share-

holders adopted in the manner required for amending these Articles of Incorporation or by a resolution of the board of
directors of the Company as set out in article 6 hereof.

The Company shall maintain a share premium account and shall book in such account the amount of any premium paid

by the shareholders. The portion of share premium necessary to fulfil the own capital requirements of the Company
under the applicable laws and regulations shall not be available for distribution.”

4. Insertion of a new article 6 within the articles of incorporation of the Company which shall read as follows and

subsequent renumbering of the following articles of the articles of incorporation of the Company accordingly as well as
all references to them:

“ Art. 6.
6.1 The authorised capital, excluding the subscribed capital, is set at ten million euro (EUR 10,000,000.-), consisting of

one hundred thousand (100,000.-) shares without nominal value. During a period of five (5) years from the date of the
publication of these Articles of Incorporation in the Mémorial C or, as the case may be, of the resolution to renew, reduce
or to increase the authorised capital pursuant to this article, the board of directors is hereby authorized to issue shares,
to grant options to subscribe for shares and to issue any other instruments convertible into shares within the limit of the
authorised capital, to such persons and on such terms as it shall see fit, and specifically to proceed to such issue without
reserving a preferential subscription right to subscribe to the shares issued to the existing shareholders. Such authorisation
may be renewed through a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an
amendment of these Articles of Incorporation, each time for a period not exceeding five (5) years.

6.2. The authorised capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of

shareholders adopted in the manner required for amendments of these Articles of Incorporation.”

5. Decision of the sole shareholder to contribute an amount of five million euro (EUR 5,000,000.-) to the Company

through a contribution in cash and decision to contribute such amount to the share premium account of the Company
without issuing new shares.

6. Amendment of the first paragraph of the new article 7 of the articles of incorporation of the Company, which shall

henceforth read as follows:

“The shares in the Company shall be and remain in registered form and shall be registered in a register of shareholders.

The register of shareholders shall be kept at the registered office of the Company. Such register shall set forth the name
of each shareholder, his residence or elected domicile, the number of shares held by him, the amounts paid in on each
such share, and the transfer of shares and the dates of such transfers.”

7. Amendment of the first paragraph of the new article 10 of the articles of incorporation of the Company, which shall

henceforth read as follows:

“The quorums and delays required by law shall govern the notice and conduct of the meetings of shareholders of the

Company, unless otherwise provided herein. Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of
shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by electronic mail or facsimile.”

8. Amendment of the first paragraph of the new article 11 of the articles of incorporation of the Company, which shall

henceforth read as follows:

“Shareholders will meet upon call by the board of directors, pursuant to notice setting forth the agenda sent by

registered mail at least eight days prior to the meeting to each shareholder at the shareholder’s address in the register
of shareholders.”

9. Amendment of the new article 12 of the articles of incorporation of the Company, which shall henceforth read as

follows:

“The Company shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need not be

shareholders of the Company. The directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting, for a
term not exceeding six years and until their successors are elected and qualify, provided, however, that a director may
be removed with or without cause and/or replaced at any time by a resolution adopted by the general meeting of sha-
reholders. In the event of a vacancy in the office of director because of death, retirement or otherwise, the remaining
directors may meet and may elect, by a majority vote, a director to fill such vacancy until the next general meeting of
shareholders. In the event that, in any meeting of the board of directors the number of votes for and against a resolution
shall be equal, the chairman shall have a casting vote. If a legal entity is appointed as director, such legal entity must
designate a physical person as its permanent representative who shall perform this role in the name and on behalf of the
legal entity. The relevant legal entity may only remove its permanent representative if it appoints his successor at the
same time.”

166438

L

U X E M B O U R G

10. Amendment of the second and third paragraphs of the new article 13 of the articles of incorporation of the

Company, which shall henceforth read as follows:

“Notice of any meeting of the board of directors shall be given to all directors at least twenty-four hours in advance

of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances
shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by electronic mail or
facsimile of each director. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed
in a schedule previously adopted by resolution of the board of directors.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by electronic mail or facsimile

another director as his proxy. The board of directors can deliberate or act validly only if at least the majority of the
directors are present or represented at a meeting of the board of directors.”

11. Amendment of the second and third paragraphs of the new article 16 of the articles of incorporation of the

Company, which shall henceforth read as follows:

“The term "personal interest", as used in the preceding sentence, shall not include any relationship with or interest in

any matter, position or transaction involving any entity of the Investec Group or any subsidiary or any affiliate thereof or
such other corporation or entity as may from time to time be determined by the board of directors in its discretion.

The Company may indemnify any director or officer, and his heirs, executors and administrators, against expenses

reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a director or officer of the Company, or, at its request, of any other corporation of which
the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to
matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for negligence or misconduct;
in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the
settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a
breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.”

12. Amendment of the new article 18 of the articles of incorporation of the Company, which shall henceforth read as

follows:

“The accounts of the Company shall be audited by an approved statutory auditor. The approved statutory auditor

shall be appointed and removed by the shareholders at the general meeting who shall determine its office term and fees.
The approved statutory auditor shall fulfil its duties in accordance with the 2010 Law.”

13. Amendment of the new article 23 of the articles of incorporation of the Company, which shall henceforth read as

follows:

“All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the 1915 Law.”
14. Miscellaneous.
After having duly deliberated on all the items of the agenda, the Meeting unanimously took the following resolutions

and requested the officiating notary to record as follows:

<i>First Resolution

The Meeting unanimously resolved to amend article 3 of the articles of incorporation of the Company, which shall

henceforth read as follows:

“The object of the Company is the collective portfolio management of one or several Luxembourg and/or foreign

collective investment funds in transferable securities authorised according to Directive 2009/65/EC (as may be amended
from time to time) (“UCITS”) and of other Luxembourg and foreign collective investment funds not covered by this
Directive (“UCI”) (together, the “Funds”) on behalf of their unit-holders or shareholders in accordance with the provi-
sions of chapter 15 of the Luxembourg law of 17 December 2010 on undertakings for collective investment (as amended
from time to time) (the “2010 Law”).

The Company may also serve as advisor to the Funds in connection with the management of their assets and their

promotion/distribution.

The activity of collective portfolio management of the Funds includes the following functions:
- Investment Management. In this regard, the Company may, for the account of the Funds: (i) provide investment advice

and make investment decisions, (ii) enter into agreements, (iii) buy, sell, exchange and deliver any sort of transferable
securities and/or other acceptable types of assets, and (iv) exercise all voting rights pertaining to securities held by the
Funds under management. This enumeration is not exhaustive.

- Administration of Funds. This function includes all activities listed under “Administration” in Annex II of the 2010

Law i.e. namely (i) the valuation of the Funds’ portfolios and the pricing of the units/shares, (ii) the issue and redemption
of the units/shares of the Funds, (iii) the maintenance of units/shares holder registers, and (iv) the record keeping of
transactions. This enumeration is not exhaustive.

- Distribution and marketing of the units/shares of the Funds within and outside of Luxembourg.
The Company may perform part or all of these activities for any UCITS and/or UCI and/or any other management

companies as a delegate.

166439

L

U X E M B O U R G

The Company may provide services within and outside of Luxembourg and may for that purpose establish represen-

tative offices and/or branches.

The Company may also administer its own assets on an ancillary basis and carry out any operations which it may deem

useful in the accomplishment and development of its purposes as well as any other activity authorised under all applicable
laws and in particular, under the law of 10 August 1915 on commercial companies (as amended from time to time) (the
"1915 Law") and Chapter 15 of the 2010 Law.”

<i>Second Resolution

The Meeting unanimously resolved to amend article 4 of the articles of incorporation of the Company, which shall

henceforth read as follows:

“The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, in the Grand Duchy of Luxembourg. Bran-

ches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

The registered office of the Company may be transferred by a decision of the board of directors provided that it

remains in Luxembourg-City.

In the event that the board of directors determines that extraordinary political or military developments have occurred

or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease
of communication between such office and persons in any other location, the registered office may be temporarily trans-
ferred outside of the Grand Duchy of Luxembourg until the complete cessation of these abnormal circumstances; such
temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer
of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such declaration of the transfer of the registered office shall
be made and brought to the attention of third parties by one of the executive organs of the Company which has powers
to commit the Company for acts of daily and ordinary management.”

<i>Third Resolution

The Meeting unanimously resolved to amend article 5 of the articles of incorporation of the Company, which shall

henceforth read as follows:

“The subscribed capital of the Company is set at one hundred and twenty five thousand euro (EUR 125,000.-) repre-

sented by one thousand two hundred and fifty (1,250) ordinary shares, fully paid up, without nominal value.

A general meeting of shareholders, held in accordance with Luxembourg law, may approve the creation of other classes

of shares, notably the creation, by issuance or conversion, of shares without voting rights but benefiting from other
preferred rights.

The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of a general meeting of share-

holders adopted in the manner required for amending these Articles of Incorporation or by a resolution of the board of
directors of the Company as set out in article 6 hereof.

The Company shall maintain a share premium account and shall book in such account the amount of any premium paid

by the shareholders. The portion of share premium necessary to fulfil the own capital requirements of the Company
under the applicable laws and regulations shall not be available for distribution.”

<i>Fourth Resolution

The Meeting unanimously resolved to insert a new article 6 within the articles of incorporation of the Company which

shall read as follows:

“ Art. 6.
6.1 The authorised capital, excluding the subscribed capital, is set at ten million euro (EUR 10,000,000.-), consisting of

one hundred thousand (100,000.-) shares without nominal value. During a period of five (5) years from the date of the
publication of these Articles of Incorporation in the Mémorial C or, as the case may be, of the resolution to renew, reduce
or to increase the authorised capital pursuant to this article, the board of directors is hereby authorized to issue shares,
to grant options to subscribe for shares and to issue any other instruments convertible into shares within the limit of the
authorised capital, to such persons and on such terms as it shall see fit, and specifically to proceed to such issue without
reserving a preferential subscription right to subscribe to the shares issued to the existing shareholders. Such authorisation
may be renewed through a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an
amendment of these Articles of Incorporation, each time for a period not exceeding five (5) years.

6.2 The authorised capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of

shareholders adopted in the manner required for amendments of these Articles of Incorporation.”

The meeting approved the waiver of the preferential subscription right of the shareholders within the limits of the

authorized capital, after having got knowledge of the special report of the board of directors according to article 32-3(5)
of the law on commercial companies, hereto attached.

As a result of the above resolution, the Meeting unanimously resolved to renumber the following articles of the articles

of incorporation of the Company as well as all references to them within the articles of incorporation.

166440

L

U X E M B O U R G

<i>Fifth Resolution

The share premium account of the Company being thus created by the above third resolution, the Meeting unanimously

resolved to contribute an amount of five million euro (EUR 5,000,000.-) to the Company through a contribution in cash
and the Meeting further resolved to contribute such amount to the share premium account of the Company without
issuing new shares.

The proof of the existence and of the payment by the sole shareholder of the Company of the amount of five million

euro (EUR 5,000,000.-) through a contribution in cash has been produced to the undersigned notary.

<i>Sixth Resolution

The Meeting unanimously resolved to amend the first paragraph of the new article 7 of the articles of incorporation

of the Company, which shall henceforth read as follows:

“The shares in the Company shall be and remain in registered form and shall be registered in a register of shareholders.

The register of shareholders shall be kept at the registered office of the Company. Such register shall set forth the name
of each shareholder, his residence or elected domicile, the number of shares held by him, the amounts paid in on each
such share, and the transfer of shares and the dates of such transfers.”

<i>Seventh Resolution

The Meeting unanimously resolved to amend the first paragraph of the new article 10 of the articles of incorporation

of the Company, which shall henceforth read as follows:

“The quorums and delays required by law shall govern the notice and conduct of the meetings of shareholders of the

Company, unless otherwise provided herein. Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of
shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by electronic mail or facsimile.”

<i>Eighth Resolution

The Meeting unanimously resolved to amend the first paragraph of the new article 11 of the articles of incorporation

of the Company, which shall henceforth read as follows:

“Shareholders will meet upon call by the board of directors, pursuant to notice setting forth the agenda sent by

registered mail at least eight days prior to the meeting to each shareholder at the shareholder’s address in the register
of shareholders.”

<i>Ninth Resolution

The Meeting unanimously resolved to amend the new article 12 of the articles of incorporation of the Company, which

shall henceforth read as follows:

“The Company shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need not be

shareholders of the Company. The directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting, for a
term not exceeding six years and until their successors are elected and qualify, provided, however, that a director may
be removed with or without cause and/or replaced at any time by a resolution adopted by the general meeting of sha-
reholders. In the event of a vacancy in the office of director because of death, retirement or otherwise, the remaining
directors may meet and may elect, by a majority vote, a director to fill such vacancy until the next general meeting of
shareholders. In the event that, in any meeting of the board of directors the number of votes for and against a resolution
shall be equal, the chairman shall have a casting vote. If a legal entity is appointed as director, such legal entity must
designate a physical person as its permanent representative who shall perform this role in the name and on behalf of the
legal entity. The relevant legal entity may only remove its permanent representative if it appoints his successor at the
same time.”

<i>Tenth Resolution

The Meeting unanimously resolved to amend the second and third paragraphs of the new article 13 of the articles of

incorporation of the Company, which shall henceforth read as follows:

“Notice of any meeting of the board of directors shall be given to all directors at least twenty-four hours in advance

of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances
shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by electronic mail or
facsimile of each director. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed
in a schedule previously adopted by resolution of the board of directors.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by electronic mail or facsimile

another director as his proxy. The board of directors can deliberate or act validly only if at least the majority of the
directors are present or represented at a meeting of the board of directors.”

<i>Eleventh Resolution

The Meeting unanimously resolved to amend the second and third paragraphs of the new article 16 of the articles of

incorporation of the Company, which shall henceforth read as follows:

166441

L

U X E M B O U R G

“The term "personal interest", as used in the preceding sentence, shall not include any relationship with or interest in

any matter, position or transaction involving any entity of the Investec Group or any subsidiary or any affiliate thereof or
such other corporation or entity as may from time to time be determined by the board of directors in its discretion.

The Company may indemnify any director or officer, and his heirs, executors and administrators, against expenses

reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a director or officer of the Company, or, at its request, of any other corporation of which
the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to
matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for negligence or misconduct;
in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the
settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a
breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.”

<i>Twelfth Resolution

The Meeting unanimously resolved to amend the new article 18 of the articles of incorporation of the Company, which

shall henceforth read as follows:

“The accounts of the Company shall be audited by an approved statutory auditor. The approved statutory auditor

shall be appointed and removed by the shareholders at the general meeting who shall determine its office term and fees.
The approved statutory auditor shall fulfil its duties in accordance with the 2010 Law.”

<i>Thirteenth Resolution

The Meeting unanimously resolved to amend the new article 23 of the articles of incorporation of the Company, which

shall henceforth read as follows:

“All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the 1915 Law”.
There being no further business before the Meeting, the same was there upon adjourned.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing, all known to the notary by their names, first names and

residences, the said persons signed together with the notary, the present deed.

Follows the french translation:

L’an deux mille quatorze, le vingt-deux octobre.
Par devant nous, Maître Henri Hellinckx, notaire, résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est tenue

une assemblée générale extraordinaire (l’«Assemblée») de l’actionnaire unique de Investec Asset Management Lu-

xembourg S.A., une société anonyme constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social
au 32-36, Boulevard d’Avranches, L-1160 Luxembourg, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 162.485 (la «Société»), initialement constituée sous le nom «SCOR Alternative Investments
S.A., Société Anonyme» selon acte reçu par Maître Henri Hellinckx en date du 8 juillet 2011 et publié au Mémorial C,
Recueil des Société et Associations N° 1802 du 8 août 2011. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois selon acte
reçu par Maître Henri Hellinckx le 30 avril 2014 et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N°1272
du 19 mai 2014.

L’Assemblée s’est ouverte à 14h30, heure de Luxembourg, sous la présidence de Madame Michèle Kemp, Avocat à la

Cour, résidant professionnellement à Luxembourg,

Le président a désigné comme secrétaire Madame Camille Delacoute, Avocat, résidant professionnellement à Luxem-

bourg, et a choisi comme scrutateur Madame Fabienne Moreau, Juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau de l’Assemblée ayant ainsi été constitué, le président a déclaré et prié le notaire instrumentant de prendre

acte que:

I. Les noms des actionnaires présents à l’Assemblée ou dûment représentés par une procuration, des mandataires des

actionnaires représentés, ainsi que le nombre d’actions détenues par chaque actionnaire, sont indiqués sur une liste de
présence, signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau de
l’Assemblée et le notaire. Ladite liste restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d’enre-
gistrement. Les procurations données seront paraphées ne varietur par les membres du bureau de l’Assemblée et par le
notaire et resteront également annexées au présent acte.

Il. Il ressort de la liste de présence, qui doit rester annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui pour

les formalités de l’enregistrement, que cent pour cent (100%) des actions de la Société sont présentes ou représentées
à l’Assemblée.

166442

L

U X E M B O U R G

III. Conformément aux dispositions des statuts de la Société et de l’article 67-1 (2) de la loi Luxembourgeoise du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, le quorum d’au moins la moitié du capital est requis pour
délibérer sur chaque point à l’ordre du jour et les résolutions sur les points à l’ordre du jour doivent être valablement
adoptées par un vote affirmatif d’au moins deux tiers des votes valablement exprimés à l’Assemblée.

IV. La totalité du capital social étant présent ou représenté à l’Assemblée et tous les actionnaires présents ou repré-

sentés déclarant avoir eu notification et connaissance préalable de l’ordre du jour de l’Assemblée avant la tenue de celle-
ci, il a été renoncé au délai de convocation de huit (8) jours avant la tenue de l’Assemblée.

V. L’Assemblée est valablement constituée et peut donc délibérer sur les points de l’ordre du jour suivant:

<i>Agenda

1. Modification de l’article 3 des statuts de la Société, qui se lira désormais comme suit:
«L’objet de la Société est la gestion collective de portefeuille d’un ou plusieurs fonds d’investissement luxembourgeois

et/ou étrangers investissant en valeurs mobilières, autorisés conformément à la Directive 2009/65/CE, telle que modifiée
(«OPCVM»),  et  d’autres  fonds  d’investissement  luxembourgeois  et/ou  étrangers  qui  ne  relèvent  pas  de  la  Directive
2009/65/CE («OPC») (ensemble, les «Fonds») pour le compte de leurs porteurs de parts ou de leurs actionnaires, con-
formément aux dispositions du chapitre 15 de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 concernant les organismes
de placement collectif, telle que modifiée (la «Loi de 2010»).

La Société peut également agir en tant que conseiller de tels Fonds en ce qui concerne la gestion des actifs de ces

Fonds ainsi que leur promotion/distribution.

L’activité de gestion collective de portefeuille de ces Fonds comprend les fonctions suivantes:
- La gestion de portefeuille. A ce titre, la Société pourra, pour le compte des Fonds, (i) fournir des conseils en inves-

tissement ou prendre des décisions d’investissement, (ii) conclure des contrats, (iii) acheter, vendre, échanger et délivrer
tout type de valeurs mobilières et/ou d’autres types d’actifs autorisés, et (iv) exercer tout droit de vote relatif aux titres
détenus par les Fonds sous gestion. Cette énumération n’est pas exhaustive.

- L’Administration des Fonds. Cette fonction comprend les activités mentionnées au paragraphe intitulé «Administra-

tion» de l’Annexe II de la Loi de 2010, à savoir respectivement (i) l’évaluation du portefeuille des Fonds et la détermination
de la valeur des actions et /ou des parts, (ii) l’émission et le rachat des actions et/ou des parts des Fonds, (iii) la tenue du
registre des actionnaires et porteurs de parts, et (iv) l’enregistrement et la conservation des opérations. Cette énumé-
ration n’est pas exhaustive.

- La distribution et commercialisation des parts/actions des Fonds au Luxembourg et à l’étranger.
La Société pourra fournir tout ou partie de ces activités pour des OPCVM, OPC et/ ou d’autres sociétés de gestion

en tant que déléguée.

La Société peut fournir des services au Luxembourg ou en dehors du Grand-Duché de Luxembourg et peut à cette

fin, établir des bureaux de représentation et/ou des filiales.

La Société peut également gérer ses propres avoirs à titre accessoire et effectuer toutes opérations qu’elle estimera

utiles à l’accomplissement et au développement de son objet social, ainsi que toute autre activité autorisée par les lois
applicables et en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu’elle pourra être
modifiée (la «Loi de 1915») et par le chapitre 15 de la Loi de 2010.»

2. Modification de l’article 4 des statuts de la Société, qui se lira désormais comme suit:
«Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville, au Grand-Duché de Luxembourg. Des filiales ou d’autres

bureaux peuvent être ouverts au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger sur décision du conseil d’administration.

Le siège social de la Société peut être transféré par décision du conseil d’administration pour autant qu’il demeure à

Luxembourg-Ville.

Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire de

nature à compromettre l’activité normale de la Société à son siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de
ce siège avec tout autre endroit se sont produits ou sont imminents, le siège social pourra être transféré temporairement
en dehors du Grand-Duché de Luxembourg, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure
provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège,
restera luxembourgeoise. Cette déclaration de transfert de siège social devra être portée à la connaissance des tiers par
un des organes dirigeants de la Société qui a les pouvoirs d'engager la Société par des actes de gestion journalière et
ordinaire.»

3. Modification de l’article 5 des statuts de la Société, qui se lira désormais comme suit:
«Le capital souscrit de la Société est fixé à cent vingt-cinq mille euros (EUR 125.000,-) représenté par mille deux cent

cinquante (1.250) actions ordinaires, entièrement libérées, et sans valeur nominale.

Conformément à la loi luxembourgeoise, l’assemblée générale des actionnaires, peut approuver la création d’autres

classes d'actions, notamment de la création par émission ou conversion, d'actions sans droit de vote mais bénéficiant
d'autres droits préférentiels.

166443

L

U X E M B O U R G

Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou diminué par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des Statuts ou par décision du conseil d’administration de la Société tel
qu’énoncé à l’article 6.

La Société doit maintenir un compte de prime d’émission et inscrira dans ce compte le montant de toute prime

d’émission payée par les actionnaires. La part de la prime d’émission nécessaire au respect des exigences de fonds propres
de la Société en application des lois et règlements applicables ne sera pas disponible pour distribution.»

4. Insertion d’un nouvel article 6 dans les statuts de la Société qui se lira comme suit et renumérotation des articles

suivants des statuts de la Société en conséquence ainsi que toutes les références aux articles contenues dans les statuts:

« Art. 6.
6.1 Le capital autorisé, excluant le capital souscrit, est fixé à un montant de dix million d’euros (EUR 10.000.000.-),

représenté par cent mille (100.000.-) actions sans valeur nominale. Pendant une période de cinq (5) ans à compter de la
date de publication des présents Statuts dans le Mémorial C ou le cas échéant de la décision de renouveler, diminuer ou
d’augmenter le capital autorisé conformément à cet article, le conseil d’administration est autorisé à émettre des actions,
à attribuer des bons de souscription d’actions et à émettre tout autre type d’instrument convertible en actions dans les
limites du capital autorisé au profit des personnes et aux conditions qu’il estimera opportunes lui permettant notamment
de procéder à cette émission sans qu’un droit préférentiel de souscription aux actions émises ne soit réservé aux ac-
tionnaires existants. Cette autorisation pourra être renouvelée par une décision de l’assemblée générale des actionnaires,
prise aux conditions requises pour la modification des Statuts, à chaque fois pour une période ne pouvant excéder une
durée de cinq (5) ans.

6.2 Le capital autorisé de la Société pourra être augmenté ou réduit par une décision de l’assemblée générale des

actionnaires, prise aux conditions requises pour la modification des Statuts.»

5. Décision de l’actionnaire unique de contribuer un montant de cinq millions d’euros (EUR 5.000.000.-) à la Société

par un apport en numéraire et décision de contribuer un tel montant au compte de prime d’émission de la Société sans
émission de nouvelle action.

6. Modification du premier paragraphe du nouvel article 7 des statuts de la Société, qui se lira désormais comme suit:
«Les actions de la Société seront et resteront nominatives et seront inscrites au registre des actionnaires. Il sera tenu

au siège social de la Société le registre des actionnaires. Ce registre contiendra le nom de chaque actionnaire, sa résidence
ou son domicile élu, le nombre des actions qu'il détient, le montant libéré de chaque action, les cessions d'actions et la
date de ces cessions.»

7. Modification du premier paragraphe du nouvel article 10 des statuts de la Société, qui se lira désormais comme suit:
«Les quorums et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la Société, dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé dans les présents Statuts. Toute action donne droit à
une voix. Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant un mandataire par écrit, ou
par courrier électronique ou télécopie.»

8. Modification du premier paragraphe du nouvel article 11 des statuts de la Société, qui se lira désormais comme suit:
«Les assemblées des actionnaires seront convoquées par le conseil d’administration, à la suite d'un avis énonçant l’ordre

du jour envoyé par lettre recommandée, au moins huit jours avant l’assemblée, à chaque actionnaire à son adresse portée
au registre des actionnaires.»

9. Modification du nouvel article 12 des statuts de la Société, qui se lira désormais comme suit:
«La Société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, lesquels n’auront

pas besoin d’être actionnaires de la Société. Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale annuelle des ac-
tionnaires pour une période ne dépassant pas six ans et jusqu’à ce que leurs successeurs aient été élus; toutefois, un
administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision des actionnaires
réunis en assemblée générale. Au cas où le poste d’un administrateur deviendrait vacant à la suite de décès, de retraite,
ou pour quelqu’autre cause, les administrateurs restants pourront se réunir et élire à la majorité des voix un adminis-
trateur pour remplir provisoirement les fonctions attachées au poste devenu vacant, jusqu’à la prochaine assemblée
générale des actionnaires. Au cas où, lors d’une réunion du conseil d’administration, il y a égalité de voix en faveur et en
défaveur d’une résolution, le président aura voix prépondérante. Si une personne morale est nommée comme adminis-
trateur, cette personne morale devra désigner une personne physique comme représentant permanent qui exercera le
mandat au nom et pour le compte de cette personne morale. La personne morale ne peut révoquer son représentant
qu’à la condition de lui avoir désigné en même temps un successeur.»

10. Modification des deuxièmes et troisièmes paragraphes du nouvel article 13 des statuts de la Société, qui se liront

désormais comme suit:

«Avis de toute réunion du conseil d’administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre heures

avant l’heure prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature de cette urgence sera mentionnée dans
l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment par écrit ou par courrier
électronique ou télécopie de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du
conseil d’administration se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée
par le conseil d’administration.

166444

L

U X E M B O U R G

Tout administrateur pourra se faire représenter à une réunion du conseil d’administration par un autre administrateur

mandaté en le désignant par écrit ou par courrier électronique ou télécopie. Le conseil d’administration ne pourra déli-
bérer et agir valablement que si au moins la majorité des administrateurs est présente ou représentée lors de la réunion
du conseil d’administration.»

11. Modification des deuxièmes et troisièmes paragraphes du nouvel article 16 des statuts de la Société, qui se liront

désormais comme suit:

«Le terme «intérêt personnel», tel qu’il est utilisé dans la phrase qui précède, n’inclut pas les relations ou les intérêts

qui pourront exister de quelque manière, en quelque qualité, ou à quelque titre que ce soit, en rapport avec toute entité
du Groupe Investec ou l’une de ses filiales ou l’un de ses affiliés, ou toute autre société ou entité que le conseil d’admi-
nistration pourra déterminer discrétionnairement en temps opportun.

La Société pourra indemniser tout administrateur ou fondé de pouvoir, ses héritiers, exécuteurs testamentaires et

administrateurs, des dépenses raisonnablement occasionnées par toutes actions ou procès auxquels il aura été partie en
sa qualité d’administrateur ou de fondé de pouvoir de la Société ou pour être ou avoir été, à la demande de la Société,
administrateur ou fondé de pouvoir de toute autre société dont la Société est actionnaire ou créditrice par laquelle il ne
serait pas indemnisé, sauf le cas où dans pareils actions ou procès il sera finalement condamné pour négligence ou mauvaise
administration; en cas d’arrangement extrajudiciaire, une telle indemnité ne sera accordée que si la Société est informée
par son avocat-conseil que la personne à indemniser n’a pas commis un tel manquement à ses devoirs. Le droit à indem-
nisation n’exclura pas d’autres droits dans le chef de l’administrateur ou du fondé de pouvoir.»

12. Modification du nouvel article 18 des statuts de la Société, qui se lira désormais comme suit:
«Les comptes de la Société seront vérifiés par un réviseur d’entreprises agréé. Le réviseur d’entreprises agréé sera

nommé et révoqué par les actionnaires réunis en assemblée générale qui fixera ses émoluments ainsi que la durée de son
mandat. Le réviseur d’entreprises agréé devra accomplir sa mission en conformité avec la Loi de 2010.»

13. Modification du nouvel article 23 des statuts de la Société, qui se lira désormais comme suit:
«Tous les points non réglés par les présents Statuts devront être réglés conformément à la Loi de 1915.»
14. Divers
Après avoir dûment délibéré sur les points à l’ordre du jour, l’Assemblée a adopté à l’unanimité les résolutions suivantes

et a requis le notaire instrumentant de bien vouloir acter ce qui suit:

<i>Première résolution

L’Assemblée a décidé à l’unanimité de modifier l’article 3 des statuts de la Société, qui se lira désormais comme suit:
«L’objet de la Société est la gestion collective de portefeuille d’un ou plusieurs fonds d’investissement luxembourgeois

et/ou étrangers investissant en valeurs mobilières, autorisés conformément à la Directive 2009/65/CE, telle que modifiée
(«OPCVM»),  et  d’autres  fonds  d’investissement  luxembourgeois  et/ou  étrangers  qui  ne  relèvent  pas  de  la  Directive
2009/65/CE («OPC») (ensemble, les «Fonds») pour le compte de leurs porteurs de parts ou de leurs actionnaires, con-
formément aux dispositions du chapitre 15 de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 concernant les organismes
de placement collectif, telle que modifiée (la «Loi de 2010»).

La Société peut également agir en tant que conseiller de tels Fonds en ce qui concerne la gestion des actifs de ces

Fonds ainsi que leur promotion/distribution.

L’activité de gestion collective de portefeuille de ces Fonds comprend les fonctions suivantes:
- La gestion de portefeuille. A ce titre, la Société pourra, pour le compte des Fonds, (i) fournir des conseils en inves-

tissement ou prendre des décisions d’investissement, (ii) conclure des contrats, (iii) acheter, vendre, échanger et délivrer
tout type de valeurs mobilières et/ou d’autres types d’actifs autorisés, et (iv) exercer tout droit de vote relatif aux titres
détenus par les Fonds sous gestion. Cette énumération n’est pas exhaustive.

- L’Administration des Fonds. Cette fonction comprend les activités mentionnées au paragraphe intitulé «Administra-

tion» de l’Annexe II de la Loi de 2010, à savoir respectivement (i) l’évaluation du portefeuille des Fonds et la détermination
de la valeur des actions et /ou des parts, (ii) l’émission et le rachat des actions et/ou des parts des Fonds, (iii) la tenue du
registre des actionnaires et porteurs de parts, et (iv) l’enregistrement et la conservation des opérations. Cette énumé-
ration n’est pas exhaustive.

- La distribution et commercialisation des parts/actions des Fonds au Luxembourg et à l’étranger.
La Société pourra fournir tout ou partie de ces activités pour des OPCVM, OPC et/ ou d’autres sociétés de gestion

en tant que déléguée.

La Société peut fournir des services au Luxembourg ou en dehors du Grand-Duché de Luxembourg et peut à cette

fin, établir des bureaux de représentation et/ou des filiales.

La Société peut également gérer ses propres avoirs à titre accessoire et effectuer toutes opérations qu’elle estimera

utiles à l’accomplissement et au développement de son objet social, ainsi que toute autre activité autorisée par les lois
applicables et en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu’elle pourra être
modifiée (la «Loi de 1915») et par le chapitre 15 de la Loi de 2010.»

166445

L

U X E M B O U R G

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée a décidé à l’unanimité de modifier l’article 4 des statuts de la Société, qui se lira désormais comme suit:
«Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville, au Grand-Duché de Luxembourg. Des filiales ou d’autres

bureaux peuvent être ouverts au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger sur décision du conseil d’administration.

Le siège social de la Société peut être transféré par décision du conseil d’administration pour autant qu’il demeure à

Luxembourg-Ville.

Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire de

nature à compromettre l’activité normale de la Société à son siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de
ce siège avec tout autre endroit se sont produits ou sont imminents, le siège social pourra être transféré temporairement
en dehors du Grand-Duché de Luxembourg, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure
provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège,
restera luxembourgeoise. Cette déclaration de transfert de siège social devra être portée à la connaissance des tiers par
un des organes dirigeants de la Société qui a les pouvoirs d'engager la Société par des actes de gestion journalière et
ordinaire.»

<i>Troisième résolution

L’Assemblée a décidé à l’unanimité de modifier l’article 5 des statuts de la Société, qui se lira désormais comme suit:
«Le capital souscrit de la Société est fixé à cent vingt-cinq mille euros (EUR 125.000,-) représenté par mille deux cent

cinquante (1.250) actions ordinaires, entièrement libérées, et sans valeur nominale.

Conformément à la loi luxembourgeoise, l’assemblée générale des actionnaires, peut approuver la création d’autres

classes d'actions, notamment de la création par émission ou conversion, d'actions sans droit de vote mais bénéficiant
d'autres droits préférentiels.

Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou diminué par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des Statuts ou par décision du conseil d’administration de la Société tel
qu’énoncé à l’article 6.

La Société doit maintenir un compte de prime d’émission et inscrira dans ce compte le montant de toute prime

d’émission payée par les actionnaires. La part de la prime d’émission nécessaire au respect des exigences de fonds propres
de la Société en application des lois et règlements applicables ne sera pas disponible pour distribution.»

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée a décidé à l’unanimité d’insérer un nouvel article 6 dans les statuts de la Société, qui se lira comme suit:

« Art. 6.
6.1 Le capital autorisé, excluant le capital souscrit, est fixé à un montant de dix million d’euros (EUR 10.000.000.-),

représenté par cent mille (100.000.-) actions sans valeur nominale. Pendant une période de cinq (5) ans à compter de la
date de publication des présents Statuts dans le Mémorial C ou le cas échéant de la décision de renouveler, diminuer ou
d’augmenter le capital autorisé conformément à cet article, le conseil d’administration est autorisé à émettre des actions,
à attribuer des bons de souscription d’actions et à émettre tout autre type d’instrument convertible en actions dans les
limites du capital autorisé au profit des personnes et aux conditions qu’il estimera opportunes lui permettant notamment
de procéder à cette émission sans qu’un droit préférentiel de souscription aux actions émises ne soit réservé aux ac-
tionnaires existants. Cette autorisation pourra être renouvelée par une décision de l’assemblée générale des actionnaires,
prise aux conditions requises pour la modification des Statuts, à chaque fois pour une période ne pouvant excéder une
durée de cinq (5) ans.

6.2 Le capital autorisé de la Société pourra être augmenté ou réduit par une décision de l’assemblée générale des

actionnaires, prise aux conditions requises pour la modification des Statuts.»

L’Assemblée a approuvé la suppression du droit de souscription préférentiel des actionnaires dans le cadre du capital

autorisé, après avoir entendu le rapport du conseil d’administration préparé conformément à l’article 32-3(5) de la loi
sur les sociétés commerciales, ci-annexé.

En conséquence de la résolution qui précède, l’Assemblée a décidé à l’unanimité de rénuméroter les articles suivants

des statuts de la Société ainsi que toutes références aux articles contenues dans les statuts.

<i>Cinquième résolution

Le compte prime d’émission de la Société étant ainsi créé par la troisième résolution qui précède, l’Assemblée a décidé

à l’unanimité de contribuer un montant de cinq millions d’euros (EUR 5.000.000.-) à la Société par un apport en numéraire
et a décidé de contribuer ce montant au compte prime d’émission de la Société sans émission de nouvelles actions.

La preuve de l’existence et du versement par l’actionnaire unique de la Société du montant de cinq millions d’euros

(EUR 5.000.000.-) par un apport en numéraire a été présentée au notaire instrumentant.

166446

L

U X E M B O U R G

<i>Sixième résolution

L’Assemblée a décidé à l’unanimité de modifier le premier paragraphe du nouvel article 7 des statuts de la Société, qui

se lira désormais comme suit:

«Les actions de la Société seront et resteront nominatives et seront inscrites au registre des actionnaires. Il sera tenu

au siège social de la Société le registre des actionnaires. Ce registre contiendra le nom de chaque actionnaire, sa résidence
ou son domicile élu, le nombre des actions qu'il détient, le montant libéré de chaque action, les cessions d'actions et la
date de ces cessions.»

<i>Septième résolution

L’Assemblée a décidé à l’unanimité de modifier le premier paragraphe du nouvel article 10 des statuts de la Société,

qui se lira désormais comme suit:

«Les quorums et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la Société, dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé dans les présents Statuts. Toute action donne droit à
une voix. Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant un mandataire par écrit, ou
par courrier électronique ou télécopie.»

<i>Huitième résolution

L’Assemblée a décidé à l’unanimité de modifier le premier paragraphe du nouvel article 11 des statuts de la Société,

qui se lira désormais comme suit:

«Les assemblées des actionnaires seront convoquées par le conseil d’administration, à la suite d'un avis énonçant l’ordre

du jour envoyé par lettre recommandée, au moins huit jours avant l’assemblée, à chaque actionnaire à son adresse portée
au registre des actionnaires.»

<i>Neuvième résolution

L’Assemblée a décidé à l’unanimité de modifier le nouvel article 12 des statuts de la Société, qui se lira désormais

comme suit:

«La Société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, lesquels n’auront

pas besoin d’être actionnaires de la Société. Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale annuelle des ac-
tionnaires pour une période ne dépassant pas six ans et jusqu’à ce que leurs successeurs aient été élus; toutefois, un
administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision des actionnaires
réunis en assemblée générale. Au cas où le poste d’un administrateur deviendrait vacant à la suite de décès, de retraite,
ou pour quelqu’autre cause, les administrateurs restants pourront se réunir et élire à la majorité des voix un adminis-
trateur pour remplir provisoirement les fonctions attachées au poste devenu vacant, jusqu’à la prochaine assemblée
générale des actionnaires. Au cas où, lors d’une réunion du conseil d’administration, il y a égalité de voix en faveur et en
défaveur d’une résolution, le président aura voix prépondérante. Si une personne morale est nommée comme adminis-
trateur, cette personne morale devra désigner une personne physique comme représentant permanent qui exercera le
mandat au nom et pour le compte de cette personne morale. La personne morale ne peut révoquer son représentant
qu’à la condition de lui avoir désigné en même temps un successeur.»

<i>Dixième résolution

L’Assemblée a décidé à l’unanimité de modifier les deuxième et troisième paragraphes du nouvel article 13 des statuts

de la Société, qui se liront désormais comme suit:

«Avis de toute réunion du conseil d’administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre heures

avant l’heure prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature de cette urgence sera mentionnée dans
l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment par écrit ou par courrier
électronique ou télécopie de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du
conseil d’administration se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée
par le conseil d’administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à une réunion du conseil d’administration par un autre administrateur

mandaté en le désignant par écrit ou par courrier électronique ou télécopie. Le conseil d’administration ne pourra déli-
bérer et agir valablement que si au moins la majorité des administrateurs est présente ou représentée lors de la réunion
du conseil d’administration.»

<i>Onzième résolution

L’Assemblée a décidé à l’unanimité de modifier les deuxième et troisième paragraphes du nouvel article 16 des statuts

de la Société, qui se liront désormais comme suit:

«Le terme «intérêt personnel», tel qu’il est utilisé dans la phrase qui précède, n’inclut pas les relations ou les intérêts

qui pourront exister de quelque manière, en quelque qualité, ou à quelque titre que ce soit, en rapport avec toute entité
du Groupe Investec ou l’une de ses filiales ou l’un de ses affiliés, ou toute autre société ou entité que le conseil d’admi-
nistration pourra déterminer discrétionnairement en temps opportun.

166447

L

U X E M B O U R G

La Société pourra indemniser tout administrateur ou fondé de pouvoir, ses héritiers, exécuteurs testamentaires et

administrateurs, des dépenses raisonnablement occasionnées par toutes actions ou procès auxquels il aura été partie en
sa qualité d’administrateur ou de fondé de pouvoir de la Société ou pour être ou avoir été, à la demande de la Société,
administrateur ou fondé de pouvoir de toute autre société dont la Société est actionnaire ou créditrice par laquelle il ne
serait pas indemnisé, sauf le cas où dans pareils actions ou procès il sera finalement condamné pour négligence ou mauvaise
administration; en cas d’arrangement extrajudiciaire, une telle indemnité ne sera accordée que si la Société est informée
par son avocat-conseil que la personne à indemniser n’a pas commis un tel manquement à ses devoirs. Le droit à indem-
nisation n’exclura pas d’autres droits dans le chef de l’administrateur ou du fondé de pouvoir.»

<i>Douzième résolution

L’Assemblée a décidé à l’unanimité de modifier le nouvel article 18 des statuts de la Société, qui se lira désormais

comme suit:

«Les comptes de la Société seront vérifiés par un réviseur d’entreprises agréé. Le réviseur d’entreprises agréé sera

nommé et révoqué par les actionnaires réunis en assemblée générale qui fixera ses émoluments ainsi que la durée de son
mandat. Le réviseur d’entreprises agréé devra accomplir sa mission en conformité avec la Loi de 2010.»

<i>Treizième résolution

L’Assemblée a décidé à l’unanimité de modifier le nouvel article 23 des statuts de la Société, qui se lira désormais

comme suit:

«Tous les points non réglés par les présents Statuts devront être réglés conformément à la Loi de 1915.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour de l’Assemblée, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes, Le notaire soussigné, qui comprend

et parle l’anglais, déclare qu’à la demande des personnes présentes à l’Assemblée, le présent acte est rédigé en langue
anglaise suivi d’une traduction en français et qu’à la demande de ces mêmes personnes présentes et en cas de divergence
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

L’acte ayant été lu aux personnes présentes, toutes connues du notaire par leurs noms, prénoms et résidences, lesdites

personnes ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. KEMP, C. DELACOUTE, F. MOREAU et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 octobre 2014. Relation: LAC/2014/50477. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 6 novembre 2014.

Référence de publication: 2014172040/670.
(140196895) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2014.

Swiss Life Funds (Lux) Global Infrastructure Opportunities S.C.A., SICAV-SIF, Société en Commandite

par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 28-32, place de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 177.337.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-fourth day of October.
Before us, Maître Henri Hellinckx, public notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

was held

an extraordinary general meeting of the shareholders (the “Meeting”) of Swiss Life Funds (Lux) Global Infrastructure

Opportunities S.C.A., SICAV-SIF, a société en commandite par actions (S.C.A.) qualifiying as a société d’investissement à
capital variable - fonds d’investissement spécialisé, with registered office at 28-32, place de la Gare, L-1616 Luxembourg,
registered with the Trade and Company Register of Luxembourg under the number B-177337, and incorporated pursuant
to a deed of incorporation of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, on 29 April 2013 published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 21 June 2013 under number 1474 (the “Company"). The articles of
association have not been amended since.

The Meeting was opened 9 a.m. CET under the chair of Mrs. Simone Baier, residing professionally in Luxembourg (the

“Chairman”), who appointed as secretary Mr. Arnauld Julien, residing professionally in Luxembourg.

The Meeting elected as scrutineer Mrs. Simone Baier, residing professionally in Luxembourg.
The board of the Meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the Notary to record

that:

A. That the agenda of the Meeting is the following:

166448

L

U X E M B O U R G

<i>Agenda

1. Amendment of article 5 of the articles of incorporation of the Company (the “Articles”);
2. Amendment of article 8 of the Articles, in order to correct a clerical error;
3. Consider to amend the Articles to align them with the law of 12 July 2013 on alternative investment fund managers

and implementing EU Directive 2011/61/EU of 8 June 2011 on Alternative Investment Fund Managers (the “AIFM Law”),
and amendment of article 14 of the Articles in order to reflect that the net asset value of the shares of the Company is
determined by the administrative agent of the Company under the responsibility of the alternative investment fund ma-
nager (“AIFM”);

4. Amendment of article 17 of the Articles in order to reflect that an AIFM will be appointed and to define its role;
5. Amendment of article 28 of the Articles in order to insert notably a reference to the AIFM Law;
6. Miscellaneous.
B. The general meeting has been duly convened through notices containing the above agenda sent on 14 October 2014

by registered mail to the registered shareholders.]

B. That the names of the shareholders present at the Meeting or duly represented by proxy or power of attorney, the

proxies and power of attorney of the shareholders represented, as well as the number of shares held by each shareholder,
are set forth on the attendance list, signed by the shareholders present, the proxies of the shareholders represented, the
Chairman and scrutineer and the Notary. The aforesaid list shall be attached to the present deed and registered therewith.
The proxies given shall be initialled "ne varietur" by the Chairman and scrutineer and by the Notary and shall be attached
in the same way to this document;

C. That according to the attendance list:
- out of the one (1) General Partner Share in issue, one (1) share is represented,
- out of the thirty thousand nine hundred (30,900) Participating Shares in issue, no shares are represented,
- out of the eight thousand three hundred seventy-nine point eight six three (8,379.863) Investors Shares A in issue,

eight thousand three hundred seventy-nine point eight six three (8,379.863) shares are represented,

- out of the eleven thousand nine hundred fourteen point two nine three (11,914.293) Investors Shares B in issue,

eleven thousand nine hundred fourteen point two nine three (11,914.293) shares are represented,

- out of the one hundred ninety thousand seven hundred sixty-eight point five four three (190,768.543) Investors

Shares C in issue, one hundred fifty-six thousand one hundred fifty-eight point eight six (156,158.86) shares are repre-
sented,

- out of the thirty-three thousand two hundred twenty-five point two nine one (33,225.291) Investors Shares F in

issue, no shares are present or represented.

i.e. sixty-four per cent (64 %) of the issued shares;
D. That the quorum required by the Articles in respect of the items of the agenda under chapter V “General Meetings”

article 22 “General meetings of the Partnership” is (i) a presence quorum of fifty percent (50%) of the shares issued by
the partnership at the first call and, if not achieved, with no quorum required for the second call and, (ii) the approval of
a majority of at least two-thirds (2/3) of the votes validly cast by the shareholders present or represented at the meeting,
and (iii) the consent of the general partner.

E. That it appears from the abovementioned attendance list, that one hundred seventy-six thousand four hundred fifty-

four point zero one six (176,454.016) shares, representing sixty-four per cent (64 %) of the share capital of the Company
are duly present or represented or have voted per voting form at the present Meeting.

F. That the present Meeting is therefore regularly constituted and may validly deliberate on all items of the agenda;
Having duly considered each item on the agenda, the Meeting unanimously takes, and requires the notary to enact,

the following resolutions:

<i>First resolution

The Meeting resolves to amend article 5 of the articles of incorporation of the Company (the “Articles”), which shall

henceforth read as follows:

“ Art. 5. Share Capital. The share capital of the Partnership shall be represented by shares of no nominal value and

shall at any time be equal to the total value of the net assets of the Partnership. The minimum share capital of the
Partnership cannot be lower than the level provided for by the Law of 13 February 2007 (herein after the “2007 Law”).
Such minimum capital must be reached within a period of twelve (12) months after the date on which the Partnership
has been authorised as a specialised investment fund under Luxembourg law.

The Partnership was incorporated with a subscribed share capital of thirty one thousand Euros (EUR 31,000.-) divided

into (i) one (1) General Partner Share of no nominal value with an initial par value of one hundred Euros (EUR 100.-) and
(ii) thirty thousand nine hundred (30,900) Participating Shares of no nominal value with an initial par value of one Euro
(EUR 1.-). Upon incorporation each Share was fully paid-up.

The distribution rights attached to each such class of shares are described in article 26 below.

166449

L

U X E M B O U R G

For the purposes of the consolidation of the accounts, the base currency of the Partnership shall be the lawful currency

of the participating member states of the EU to the monetary union expressed in these articles of incorporation as “Euro”
or “EUR”.

The General Partner will adopt such provisions as necessary to ensure that any preferential treatment accorded by

the Partnership, or by the AIFM of the Partnership with respect to the Partnership, as the case may be, to a shareholder
will not result in an overall material disadvantage to other shareholders, as further disclosed in the Partnership’s issuing
document.”

The resolution has been adopted by:
- One hundred sixty three thousand two hundred thirty-seven (163,237) votes approving, including the vote of the

general partner of the Company;

- no votes against;
- thirteen thousand two hundred sixteen (13,216) abstentions.

<i>Second resolution

The Meeting resolves to amend article 8 of the Articles, in order to correct a clerical error. Article 8 of the Articles

shall henceforth read as follows:

“ Art. 8. Classes of Shares. The shares of the Partnership are reserved to institutional, professional or wellinformed

investors within the meaning of the Law of 13 February 2007 and the Partnership will refuse to issue shares to the extent
the legal or beneficial ownership thereof would belong to persons or companies which do not qualify as institutional,
professional or well-informed investors within the meaning of the said law.

Each class of shares may differ from the other classes with respect to its cost structure, the initial investment required

or the currency in which the net asset value is expressed or any other feature.

The share capital of the Partnership shall be represented by the following classes of shares of no nominal value:
(i) “General Partner Share”: one management share which has been subscribed by the General Partner as unlimited

shareholder (associé gérant commandité) of the Partnership;

(ii) “Participating Shares”: a class of shares which have been subscribed upon incorporation of the Partnership and

which entitle its holder to receive the Special Return after payment of the Preferred Return (as defined in article 26
hereof);

(iii) “Investors Shares”: one or several class(es) of shares which shall be subscribed by limited shareholders (associés

commanditaires) and which entitle its holders to receive the Preferred Return and other distribution rights (as described
in article 26 below). The General Partner may decide to issue different classes of Investors Shares for the Partnership,
to be subscribed by limited shareholders (actionnaires commanditaires) and further differentiate such classes amongst
themselves, as further disclosed in the issuing documents of the Partnership.

The General Partner may, in the future, offer new classes of shares without approval of the shareholders. Such new

classes of shares may be issued on terms and conditions that differ from the existing classes of shares, including, without
limitation, the amount of the management fee attributable to those shares, and other rights relating to liquidity of shares.
In such a case, the issuing documents of the Partnership shall be updated accordingly.”

- One hundred sixty three thousand two hundred thirty-seven (163,237) votes approving, including the vote of the

general partner of the Company;

- no votes against;
- thirteen thousand two hundred sixteen (13,216) abstentions.

<i>Third resolution

The Meeting resolves to amend article 14 of the Articles in order to reflect that the net asset value of the shares of

the Company is determined by the administrative agent of the Company under the responsibility of the alternative in-
vestment fund manager (“AIFM”). Article 14 of the Articles shall henceforth read as follows:

“ Art. 14. Net Asset Value. The net asset value of the shares in every class, type or sub-type of share of the Partnership,

shall be determined at least once a year by the administrative agent of the Partnership under the responsibility of the
AIFM and expressed in the currency(ies) decided upon by the AIFM. The AIFM shall decide the days by reference to which
the assets of the Partnership shall be valued (each a “Valuation Day”) and the appropriate manner to communicate the
net asset value per share, in accordance with the legislation in force.

I. The assets of the Partnership shall include:
- all cash in hand or on deposit, including any outstanding accrued interest;
- all bills and promissory notes and accounts receivable, including outstanding proceeds of any sale of securities;
- all securities, shares, bonds, time notes, debenture stocks, options or subscription rights, warrants, money market

instruments, and all other investments and transferable securities belonging to the Partnership;

166450

L

U X E M B O U R G

- all dividends and distributions payable to the Partnership either in cash or in the form of stocks and shares (the

Partnership may, however, make adjustments to account for any fluctuations in the market value of transferable securities
resulting from practices such as ex-dividend or ex-claim negotiations);

- all outstanding accrued interest on any interest-bearing securities belonging to the Partnership, unless this interest

is included in the principal amount of such securities;

- the preliminary expenses of the Partnership, to the extent that such expenses have not already been written-off;
- the other fixed assets of the Partnership, including office buildings, equipment and fixtures; and
- all other assets whatever their nature, including the proceeds of swap transactions and advance payments.
II. The Partnership’s liabilities shall include:
- all borrowings, bills, promissory notes and accounts payable;
- all known liabilities, whether or not already due, including all contractual obligations that have reached their term,

involving payments made either in cash or in the form of assets, including the amount of any dividends declared by the
Partnership but not yet paid;

- a provision for any capital tax and income tax accrued to the Valuation Day and any other provisions authorised or

approved by the AIFM; and

-  all  other  liabilities  of  the  Partnership  of  any  kind,  except  liabilities  represented  by  shares  in  the  Partnership.  In

determining the amount of such liabilities, the Partnership shall take into account all expenses payable by the Partnership
including, but not limited to: formation expenses; expenses in connection with, and fees payable to, its investment manager
(s), adviser(s), accountants, depositary, custodian and correspondents, registrar, transfer agents, paying agents, brokers,
distributors, permanent representatives in places of registration and auditors; administration, domiciliary, services, pro-
motion,  printing,  reporting,  publishing  (including  advertising  or  preparing  and  printing  of  issuing  documents  of  the
Partnership, explanatory memoranda, registration statements, financial reports) and other operating expenses; the cost
of buying and selling assets (transaction costs); interest and bank charges, as well as taxes and other governmental charges.

The Partnership may calculate administrative and other expenses of a regular or recurring nature on an estimated

basis yearly or for other periods in advance and may accrue the same in equal proportions over any such period.

III. The value of the assets of the Partnership shall be determined as follows:
- the value of any cash in hand or on deposit, discount notes, bills and demand notes and accounts receivable, prepaid

expenses, cash dividends and interest declared or accrued as aforesaid and not yet received, shall be equal to the entire
amount thereof, unless the same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof shall be determined
after making such discount as the AIFM may consider appropriate in such case to reflect the true value thereof;

- the value of all portfolio securities and money market instruments or derivatives that are listed on an official stock

exchange or traded on any other regulated market will be based on the last available price on the principal market on
which such securities, money market instruments or derivatives are traded, as supplied by a recognised pricing service
approved by the AIFM. If such prices are not representative of the fair value, such securities, money market instruments
or derivatives as well as other permitted assets may be appraised at a fair value at which it is expected that they may be
resold, as determined in good faith under the direction of the AIFM;

- the value of securities and money market instruments which are not quoted or traded on a regulated market will be

appraised at a fair value at which they are expected to be resold, as determined in good faith under the direction of the
AIFM;

- investments in private equity securities will be appraised at a fair value under the direction of the AIFM in accordance

with appropriate professional standards, such as, without limitation, the International Private Equity and Venture Capital
Valuation Guidelines published by the European Private Equity and Venture Capital Association (EVCA), as further spe-
cified in the issuing documents of the Partnership;

- the valuation of swaps will be based on their market value, which itself depends on various factors (e.g. level and

volatility of the underlying asset, market interest rates, residual term of the swaps). Any adjustments required as a result
of issues and redemptions are carried out by means of an increase or decrease in the nominal of the swaps, traded at
their market value;

- the valuation of derivatives traded over-the-counter (OTC), such as futures, forward or option contracts not traded

on exchanges or on other recognised markets, will be based on their net liquidating value determined pursuant to the
policies established under the direction of the AIFM on the basis of recognised financial models in the market and in a
consistent manner for each category of contracts. The net liquidating value of a derivative position is to be understood
as being equal to the net unrealised profit/loss with respect to the relevant position;

- the value of other assets will be determined prudently and in good faith under the direction of the AIFM in accordance

with the generally accepted valuation principles and procedures.

The AIFM, at its discretion, may authorise the use of other methods of valuation if it considers that such methods

would enable the fair value of any asset of the Partnership to be determined more accurately.

Where necessary, the fair value of an asset is determined by the AIFM, or by a committee appointed by the AIFM, or

by a designee of the AIFM.

166451

L

U X E M B O U R G

All valuation regulations and determinations shall be interpreted and made in accordance with the valuation/accounting

principles specified in the issuing documents of the Partnership.

For each class of shares, the net asset value per share shall be calculated in the relevant reference currency with respect

to each Valuation Day by dividing the net assets attributable to such class (which shall be equal to the assets minus the
liabilities attributable to such class) by the number of shares issued and in circulation in such class; assets and liabilities
expressed in foreign currencies shall be converted into the relevant reference currency, based on the relevant exchange
rates.

In the absence of bad faith, gross negligence or manifest error, every decision to determine the net asset value taken

by the AIFM or by any bank, company or other organisation which the AIFM may appoint for such purpose, shall be final
and binding on the Partnership and present, past or future shareholders.”

- One hundred sixty three thousand two hundred thirty-seven (163,237) votes approving, including the vote of the

general partner of the Company;

- no votes against;
- thirteen thousand two hundred sixteen (13,216) abstentions.

<i>Forth resolution

The Meeting resolves to amend article 17 of the Articles, in order to reflect that an AIFM will be appointed and to

define its role. Article 17 of the Articles shall henceforth read as follows:

“ Art. 17. Powers of the General Partner. The General Partner, applying the principle of risk spreading, shall determine

the investment policies and strategies of the Partnership and the course of conduct of the management and business
affairs of the Partnership, as set forth in the issuing documents of the Partnership, in compliance with applicable laws and
regulations.

The Partnership is authorized to employ techniques and instruments to the full extent permitted by law for the purpose

of efficient portfolio management.

The General Partner is vested with the broadest powers to perform all acts of disposition and administration within

the Partnership's purpose.

All powers not expressly reserved by law or by these articles of incorporation to the general meeting of shareholders

are in the competence of the General Partner.

The General Partner may appoint committees, investment advisers and managers, as well as any other management

or administrative agents. The General Partner may enter into agreements with such persons or companies for the pro-
vision of their services, the delegation of powers to them, and the determination of their remuneration to be borne by
the Partnership.

In particular, the General Partner will appoint an alternative investment fund manager (the “AIFM”) in compliance with

the law of 12 July 2013 on alternative investment fund managers and implementing the Directive 2011/61/EU (the “2013
Law”) through an alternative investment fund management agreement as further described in the Memorandum.

The AIFM will (subject to the overall supervision, approval and direction of the General Partner) undertake portfolio

management, valuation and risk management activities for the Partnership, subject to the investment objective and policies
set by the General Partner and as set out in the Memorandum.”

- One hundred sixty three thousand two hundred thirty-seven (163,237) votes approving, including the vote of the

general partner of the Company;

- no votes against;
- thirteen thousand two hundred sixteen (13,216) abstentions.

<i>Fifth resolution

The Meeting resolves to amend article 28 of the Articles, in order to insert notably a reference to the AIFM Law.

Article 28 of the Articles shall henceforth read as follows:

“ Art. 28. Depositary. The Partnership will appoint a depositary which meets the requirements of the 2007 Law and

the 2013 Law (the “Depositary”).

The Depositary shall fulfil the duties and responsibilities as provided by the 2007 Law and the 2013 Law.
Where the law of a third country requires that certain financial instruments be held in custody by a local entity and

there are no local entity that satisfy the delegation requirements under the 2013 Law, the Partnership shall be expressly
authorised to discharge in writing the Depositary from its liability with respect to the custody of such financial instruments
to the extent it has been instructed by the Partnership or the AIFM of the Partnership, as the case may be, to delegate
the custody of such financial instruments to such local entity, and provided that the conditions of article 19(14) of the
2013 Law are met.

If the Depositary desires to withdraw, the General Partner shall use its best efforts to find a successor depositary

within two months of the effectiveness of such withdrawal. Until the Depositary is replaced, which must happen within

166452

L

U X E M B O U R G

such period of two months, the Depositary shall take all necessary steps for the good preservation of the interests of
the shareholders of the Partnership.

The General Partner may terminate the appointment of the Depositary, but shall not remove the Depositary unless

and until a successor depositary shall have been appointed to act in the place thereof.”

- One hundred sixty three thousand two hundred thirty-seven (163,237) votes approving, including the vote of the

general partner of the Company;

- no votes against;
- thirteen thousand two hundred sixteen (13,216) abstentions.
Nothing else being in the agenda, the meeting was closed.

<i>Costs and expenses

The costs, expenses, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of this deed are

estimated at EUR 1,500.-

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English only.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name,

civil status and residence, the said proxyholder of the appearing parties signed together with the Notary, the present
deed.

Signé: S. BAIER, A. JULIEN et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 octobre 2014. Relation: LAC/2014/49837. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur

 (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 6 novembre 2014.

Référence de publication: 2014172360/270.
(140196425) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2014.

Eifel S.à r.l., Société en Commandite par Actions,

(anc. Eifel Management S.à r.l. &amp; Partners S.C.A.).

Capital social: EUR 665.305,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 161.131.

In the year two thousand and fourteen, on the fourteenth of the month of November,
Before Us, Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1) Eifel S.à r.l. (f.k.a. Eifel Management S.à r.l. &amp; Partners S.C.A.), a private limited liability company (société à respon-

sabilité limitée), having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,
having a subscribed and fully paid in share capital of six hundred sixty-five thousand three hundred five Euros (EUR
665.305,00) represented by six hundred sixty-five thousand three hundred five (665.305) shares with a nominal value of
one Euro (EUR 1,00) each, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 161131,
established and existing under the laws of Luxembourg pursuant to a deed of the undersigned notary, dated March 7,
2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1833 of August 10, 2011, and whose
articles of association have been last amended pursuant to a deed of the undersigned notary dated November 6, 2014,
not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Absorbing Company),

here represented by Ms. Sofia Da Chao Conde, employee, with professional address at 5, rue Zénon Bernard, L-4030

Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg (the Attorney), by virtue of a special power of attorney granted by the
board of managers of the Absorbing Company of November 13, 2014 (the Resolutions 1), and

2) Eifel Holdings S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office

at 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, having a subscribed and fully paid in share
capital of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12.500,00) represented by twelve thousand five hundred (12.500)
shares, having a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each, registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register under number B 163855, established and existing under the laws of Luxembourg pursuant to a deed of the
undersigned notary, dated September 30, 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number
2842,  of  November  22,  2011,  and  whose  articles  of  association  have  been  last  amended  pursuant  to  a  deed  of  the
undersigned notary, of December 3, 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations number
501, of February 25, 2014 (the Absorbed Company),

166453

L

U X E M B O U R G

here represented by the Attorney by virtue of a special power of attorney granted by the board of managers of the

Absorbed Company of November 13, 2014 (the Resolutions 2).

A copy of the Resolutions 1 and the Resolutions 2 signed ne varietur by the Attorney and the undersigned notary will

remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

The Absorbing Company and the Absorbed Company are hereafter together referred to as the Merging Companies.
The Merging Companies are subject to the law of August 10, 1915 on commercial companies, as subsequently amended

(the Law).

It is acknowledged that article 268 of the Law shall not be applicable with regard to any bondholders of any company

of the Coveris Group, a single consolidated packaging businesses group also comprising Kobusch group of companies,
Paragon Print and Packaging group of companies, Britton group of companies, Exopack group of companies and PACCOR
group of companies, which the Merging Companies are part of, to the extent that all required consents have been obtained
pursuant to article 269 of the Law.

The Attorney, acting for the board of managers of the Absorbing Company and for the board of managers of the

Absorbed Company, requested the notary to draw up the merger proposal (the Merger Proposal) in the following way:

MERGER PROPOSAL

The Absorbing Company proposes to merge with the Absorbed Company by way of absorption (the Merger), it being

understood that the surviving entity will be the Absorbing Company.

The Absorbing Company is the owner of all the shares representing the entire share capital and all voting rights of the

Absorbed Company, and as such the Merger is subject to the specific provisions of article 278 of the Law.

Since the Absorbing Company holds one hundred per-cent (100%) of the shares in issue of the Absorbed Company

and to the extent all the conditions of article 279 of the Law are met, the approval of the Merger by the extraordinary
general meeting of shareholders of each of the Merging Companies will not be required.

The documents referred to in article 267, paragraph 1, a), b) and c) of the Law (i.e. the Merger Proposal, the annual

accounts and the annual reports of the Merging Companies for the last three financial years as well as an interim financial
situation as of October 31, 2014) will be available for a period of at least one month prior to the Effective Date (as defined
below) of the Merger for inspection by the shareholder(s) of the Absorbing Company at the registered office of the
Merging Companies in accordance with article 279 (1) (b) of the Law.

It is specifically mentioned that the Merger will be approved and will become effective before the merger of the

Absorbing Company with its sole shareholder, being Coveris Holdings S.A., a joint stock company (société anonyme),
having its registered office at 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with
the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 178003, established and existing under the laws of
Luxembourg pursuant to a deed of the undersigned notary, of May 29, 2013, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations number 1886 of August 5, 2013, and whose articles of association have been last amended
pursuant to a deed of the undersigned notary of December 31, 2013 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations number 518, of February 26, 2014 (Coveris), by way of absorption, it being understood that the surviving
entity will be Coveris.

For the avoidance of doubt, it is reminded that the effective date of the Merger (the Effective Date) shall be one (1)

month after the publication of this Merger Proposal in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The Merger will become effective vis-à-vis third parties as from the publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés

et Associations of the notarial certificate referred to in article 273 (1) of the Law.

Now therefore, it is agreed as follows:
1. On the Effective Date, the Absorbed Company shall, pursuant to articles 257 et seq. of the Law, contribute to the

Absorbing Company all its assets and all its liabilities, without any restriction or limitation.

2. The Merger is based on the interim accounts as of October 31, 2014 of each of the Merging Companies.
3. As from the Effective Date, all assets and liabilities of the Absorbed Company shall be deemed transferred to the

Absorbing Company.

The assets and liabilities, which are all transferred at their book value to the Absorbing Company on the Effective Date,

are evaluated per the interim accounts of the Absorbed Company as of October 31, 2014.

4. Discharge shall be granted to the managers of the Absorbed Company for the exercise of their mandates until the

Effective Date of the Merger.

5. As a result of the Merger, the Absorbed Company shall cease to exist and all its shares in issue shall be cancelled.

The activities of the Absorbed Company will be continued by the Absorbing Company.

6. No particular advantage is granted to the members of the board of managers of the Merging Companies.
7. Neither of the Merging Companies has issued securities (other than its shares) entitling their holders to a right to

vote.

8. The shares of the Absorbed Companies are free of all liens and charges and not encumbered by any security or

beneficial right or the holder of such lien, charge, security, or be otherwise permitted under the relevant loan documents.

166454

L

U X E M B O U R G

9. As the Absorbed Company do not have any employees, the Merger will not have any effect on employment.
10. The Merger shall further be subject to the following terms and conditions:
a) the Absorbing Company shall acquire the assets contributed by the Absorbed Company in the state in which they

are on the Effective Date, without any right of recourse against the Absorbed Company on whatever grounds;

b) the Absorbed Company guarantees to the Absorbing Company the existence of all receivables included in the assets

contributed but do not assume any liability as to the solvency of the debtors concerned;

c) the Absorbing Company shall subsequently to the Merger pay all taxes, contributions, duties and levies whether

ordinary or extraordinary, which are due or may become due with respect to the Absorbed Company or the property
of the assets contributed;

d) the Absorbing Company shall carry out all agreements and obligations of whatever kind of the Absorbed Company

such as these agreements and obligations exist on the Effective Date;

e) the Absorbing Company shall in particular carry out all agreements existing with the creditors of the Absorbed

Company and the Absorbing Company shall be subrogated to all rights and obligations resulting therefrom, at its own
risks;

f) the rights and claims comprised in the assets of the Absorbed Company shall be transferred to the Absorbing

Company with all securities, either in rem or personal, attached thereto. The Absorbing Company shall thus be subro-
gated, without any novation, to all rights, whether in rem or personal, of the Absorbed Company with respect to all assets
and against all debtors without any exception;

g) the Absorbing Company shall assume all liabilities of any kind of the Absorbed Company and it shall in particular

assume interest and principal on all debts and liabilities of any kind due by the Absorbed Company;

h) the Absorbing Company hereby formally waives any rights of preference, mortgage and rescission, which it may

have against the Absorbed Company as a result of the Absorbing Company assuming debts, charges and obligations of
the Absorbed Company and it explicitly dispenses the keepers of mortgages with making such an entry ex officio upon
registration of this deed.

11. From an accounting point of view, the Merger shall be deemed to be effective as from the Effective Date.
12. The Absorbing Company shall itself carry out all formalities, including such announcements as are prescribed by

Law, which are necessary or useful to carry into effect the Merger and the transfer and assignment of the assets and
liabilities of the Absorbed Company to the Absorbing Company. Insofar as required by Law or deemed necessary or
useful, appropriate transfer instruments shall be executed by the Merging Companies to effect the transfer of the assets
and liabilities contributed by the Absorbed Company to the Absorbing Company.

13. All corporate documents, files and records of the Absorbed Company shall be kept at the registered office of the

Absorbing Company for so long as the Law prescribes.

14. Insofar as not specifically provided herein, the Merging Companies refer to the Law.

<i>Formalities

The Absorbing Company:
- shall carry out all legal and publication formalities relating to the contributions made in relation to the Merger;
- shall take on the statements and necessary formalities relating to all relevant administration matters in order to put

all assets acquired in its name;

- shall carry out any formalities in order to render the transfer of goods and rights that it has received opposable to

third parties.

<i>Delivery of titles

At the definitive realisation of the Merger, the Absorbed Company will give the Absorbing Company the originals of

all its incorporating documents and amending deeds, as well as the books of accounts and other accounting documents,
titles of ownership or documentary acts of ownership of any assets, the supporting documents of the operations carried
out, securities and contracts, archives, vouchers and any other documents relating to the assets and rights transferred.

<i>Fees and duties

Any charges, duties or fees owing as a result of the Merger will be met by the Absorbing Company.
If necessary, the Absorbing Company shall pay the taxes due by the Absorbed Company on the capital and the profits,

for the fiscal years not yet taxed.

<i>Choice of the domicile

For the execution of the present deed and any subsequent ones or minutes which may arise as a result, and for any

supporting documents or notifications, the registered office of the Absorbing Company is chosen as domicile.

166455

L

U X E M B O U R G

<i>Powers

All the powers are given to the bearer of a certified copy of the present deed in order to carry out all formalities and

complete all statements, notifications, deposits, publications and other such matters.

In accordance with the provisions of article 271 (2) of the Law, the undersigned notary certifies the legality of the

present merger deed drawn up pursuant to articles 261 and 278 of the Law.

<i>Opposability toward third parties

For the purpose of opposability of the Merger toward third parties, all the powers are given to the Attorney and to

the undersigned notary in order to issue a statement in accordance with article 273 (1) of the Law, stating that the
conditions set forth under article 279 of the Law are met, and to proceed with the publication of said statement.

Whereof, the present notarised deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the day named at the beginning of this

document.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English text and the French translation, the English version will prevail.

After having read and interpreted the contents to the Attorney in a language he understands, the Attorney, known to

the Notary by his surname, first name, civil status and residence, has signed the present deed with the Notary.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le quatorze novembre,
Par-devant Nous, Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1) Eifel S.à r.l. (anciennement dénommée Eifel Management S.à r.l. &amp; Partners S.C.A.), une société à responsabilité

limitée, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, ayant un
capital social entièrement libéré de six cent soixante-cinq mille trois cent cinq Euros (EUR 665.305,00) représenté par
six cent soixante-cinq mille trois cent cinq (665.305) parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune,
enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 161131, constituée sous
les lois luxembourgeoises par acte du notaire soussigné, du 7 mars 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations numéro 1833 du 10 août 2011, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire
soussigné  du  6  novembre  2014,  non  encore  publié  au  Mémorial  C,  Recueil  des  Sociétés  et  Associations  (la  Société
Absorbante),

ici représentée par Mme Sofia Da Chao Conde, employée privée, ayant son adresse professionnelle au 5, rue Zénon

Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand-Duché du Luxembourg (le Mandataire), en vertu d'un mandat spécial accordé
par résolutions du conseil de gérance de la Société Absorbante en date du 13 novembre 2014 (les Résolutions 1), et

2) Eifel Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882

Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, ayant un capital social entièrement libéré de douze mille cinq cent Euro
(EUR 12.500,00), représenté par douze mille cinq cent (12.500) parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00)
chacune, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 163855, con-
stituée sous les lois luxembourgeoises par acte du notaire soussigné, du 30 septembre 2011, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations numéro 2842 du 22 novembre 2011, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière
fois par acte du notaire soussigné, du 3 décembre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
numéro 501 du 25 février 2014 (la Société Absorbée),

ici représentée par le Mandataire en vertu d'un mandat spécial accordé par résolutions du gérant unique de la Société

Absorbée en date du 13 novembre 2014 (les Résolutions 2).

Une copie des Résolutions 1 et des Résolutions 2 signées ne varietur par le Mandataire et le notaire soussigné resteront

annexées au présent acte en vue de leur dépôt auprès des autorités d'enregistrement.

La Société Absorbante et la Société Absorbée sont ensemble désignées ci-après comme les Sociétés Fusionnant.
Les Sociétés Fusionnant sont soumises à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée

(la Loi).

Il est reconnu que l'article 268 de la Loi ne sera pas applicable à l'égard de tout porteur d'obligations de toute société

du groupe Coveris, un groupe consolidé de sociétés d'emballage comprenant les groupes Kobusch, Paragon Print and
Packaging, Britton, Exopack et PACCOR, dont les Sociétés Fusionnant font partie, dans la mesure où tous les consente-
ments requis ont été obtenus conformément à l'article 269 de la Loi.

Le Mandataire, agissant pour le conseil de gérance de la Société Absorbante et pour le conseil de gérance de la Société

Absorbée, a requis le notaire instrumentant d'acter le projet de fusion (le Projet de Fusion) qui suit:

166456

L

U X E M B O U R G

PROJET DE FUSION

La Société Absorbante propose de fusionner avec la Société Absorbée par voie d'absorption (la Fusion), étant entendu

que la société survivante sera la Société Absorbante.

La Société Absorbante est propriétaire de toutes les parts sociales représentant l'intégralité du capital social et tous

les droits de vote de la Société Absorbée, en conséquence la Fusion est soumise aux conditions prévues à l'article 278
de la Loi.

Etant donné que la Société Absorbante détient cent pour-cent (100%) des parts sociales émises par la Société Absorbée

et dans la mesure où les conditions de l'article 279 de la Loi sont remplies, une approbation de la Fusion par l'assemblée
générale extraordinaire des associés de chacune des Sociétés Fusionnant ne sera pas requise.

Les documents mentionnés à l'article 267, paragraphe 1, a), b) et c) de la Loi (en l'occurrence le Projet de Fusion, les

comptes et rapports annuels des Sociétés Fusionnant pour les trois derniers exercices ainsi qu'un état comptable au 31
octobre 2014, seront disponibles pendant une période d'au moins un mois avant la Date d'Effet (définie ci-dessous) de la
Fusion, pour inspection par les associés de la Société Absorbante au siège social des Sociétés Fusionnant, conformément
à l'article 279 (1) (b) de la Loi.

Il est expressément mentionné que la Fusion sera approuvée et deviendra effective avant la fusion de la Société Ab-

sorbante avec son associé unique, étant Coveris Holdings S.A., une société anonyme, ayant son siège social au 5, rue
Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 178003, constituée sous les lois luxembourgeoises par acte du notaire
soussigné, du 29 mai 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1886 du 5 août 2013, et
dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire soussigné du 31 décembre 2013, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 518 du 26 février 2014 (Coveris), par voie d'absorption, étant
entendu que l'entité survivante sera Coveris.

Afin d'éviter tout doute, il est entendu que la Fusion produira ses effets (la Date d'Effet) un (1) mois au moins après

la publication de ce Projet de Fusion dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

La Fusion sera effective à l'égard des tiers à partir de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations

du certificat notarié dont il est question à l'article 273 (1) de la Loi au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Est arrêté ce qui suit:
1. A la Date d'Effet, la Société Absorbée transmettra de manière universelle et sans limitation ni restriction tous les

éléments d'actif et de passif de son patrimoine à la Société Absorbante, conformément aux articles 257 et suivants de la
Loi.

2. La Fusion repose sur les comptes intérimaires du 31 octobre 2014 de chacune des Sociétés Fusionnant.
3. A compter de la Date d'Effet, l'universalité des éléments d'actif et de passif du patrimoine de la Société Absorbée

seront transférés à la Société Absorbante.

L'actif et le passif transférés à valeur comptable à la Société Absorbante à la Date d'Effet sont évalués suivant les

comptes intérimaires de la Société Absorbée au 31 octobre 2014.

4. Décharge sera accordée aux gérants de la Société Absorbée pour l'exercice de leurs mandats jusqu'à la Date d'Effet

de la Fusion.

5. Par l'effet de la Fusion, la Société Absorbée cessera d'exister de plein droit et les parts sociales de la Société Absorbée

seront annulées. Les activités de la Société Absorbée seront reprises par la Société Absorbante.

6. Aucun avantage particulier n'a été consenti aux membres des conseils de gérance des Sociétés Fusionnant.
7. Aucune des Sociétés Fusionnant n'a émis de titres (autres que des parts sociales) conférant à leur porteur un droit

de vote.

8. Les parts sociales des Sociétés Absorbées sont libres de toutes sûretés, privilèges et droit de rétention, ou sont par

ailleurs autorisés selon les contrats de prêts y afférent.

9. La Société Absorbée n'ayant pas d'employés, la Fusion restera sans conséquence sur l'emploi.
10. La Fusion est également soumise aux termes et conditions suivants:
a) la Société Absorbante reprend les actifs transférés par la Société Absorbée en l'état dans lequel ils se trouvent à la

Date d'Effet sans aucune prétention, à quelque titre que ce soit, contre la Société Absorbée;

b) la Société Absorbée garantit à la Société Absorbante l'existence de toutes les créances comprises dans les actifs

apportés, mais n'assumera aucune responsabilité quant à la solvabilité des débiteurs concernés;

c) suite à la Fusion, la Société Absorbante payera tous les impôts, taxes et redevances, ordinaires et extraordinaires

qui pourront être exigés, eu égard de la Société Absorbée ou à la propriété des actifs transférés;

d) la Société Absorbante reprend l'intégralité des obligations et contrats de la Société Absorbée, tels qu'ils existent à

la Date d'Effet;

e) la Société Absorbante reprend en particulier l'intégralité des contrats existants avec les créanciers de la Société

Absorbée. La Société Absorbante sera subrogée dans tous les droits et obligations en découlant et ceci à ses propres
risques;

166457

L

U X E M B O U R G

f) les droits et revendications sociales attachés aux actifs transférés par la Société Absorbée seront transférés avec

l'intégralité des sûretés réelles et personnelles à la Société Absorbante. La Société Absorbante sera de ce fait subrogée,
sans qu'il n'y ait novation des contrats, dans tous les droits réels et personnels de la Société Absorbée, et ceci sans
exception pour tous les actifs et à l'égard de tous les débiteurs;

g) la Société Absorbante reprend l'intégralité des obligations de la Société Absorbée, et en particulier, la Société

Absorbante sera redevable des intérêts et du capital de toutes dettes et obligations de la Société Absorbée;

h) la Société Absorbante renonce expressément à tous droits de privilège, d'hypothèque et action résolutoire qu'elle

détient envers la Société Absorbée, du fait de la reprise des droits et obligations de cette dernière, et dispense expres-
sément le bureau des hypothèques d'effectuer cette inscription ex officio lors de l'enregistrement du présent acte.

11. D'un point de vue comptable, la Fusion produira ses effets à compter de la Date d'Effet.
12. La Société Absorbante peut accomplir toutes formalités, y compris les publications prévues par la Loi, utiles ou

nécessaires à l'entrée en vigueur de la Fusion ou servant la transmission des actifs et passifs. Si prévu par la Loi, ou lorsque
cela peut servir la transmission des actifs et passifs, les actes translatifs seront accomplis par les Sociétés Fusionnant afin
de garantir la transmission des actifs et passifs de la Société Absorbée vers la Société Absorbante.

13. Tous les documents de sociétés, actes et registres de la Société Absorbée seront conservés au siège social de la

Société Absorbante pendant la durée prévue par la Loi.

14. Pour tout point non prévu par les présentes, les parties se réfèrent à la Loi.

<i>Formalités

La Société Absorbante:
- effectuera toutes les formalités légales et de publication relatives aux apports effectués au titre de la Fusion;
- se chargera de toutes déclarations et formalités nécessaires auprès de toutes administrations compétentes pour faire

mettre à son nom les éléments d'actif apportés;

- effectuera toutes les formalités en vue de rendre opposable aux tiers la transmission des biens et droits reçus.

<i>Remise de titres

Lors de la réalisation définitive de la Fusion, la Société Absorbée remettra à la Société Absorbante les originaux de

tous ses documents constitutifs et modificatifs ainsi que les livres de comptabilité et autres documents comptables, les
titres de propriété ou actes justificatifs de propriété de tous les éléments d'actif, les justificatifs des opérations réalisées,
les valeurs mobilières ainsi que tous contrats, archives, pièces et autres documents quelconques relatifs aux éléments et
droits transférés.

<i>Frais et droits

Tous frais, droits et honoraires dus au titre de la Fusion seront supportés par la Société Absorbante.
La Société Absorbante acquittera, le cas échéant, les impôts dus par la Société Absorbée sur le capital et les bénéfices

au titre des exercices non encore imposés définitivement.

<i>Election de domicile

Pour l'exécution des présentes et des actes ou procès-verbaux qui en seront la suite ou la conséquence ainsi que pour

toutes justifications et notifications, il est fait élection de domicile au siège social de la Société Absorbante.

<i>Pouvoirs

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie certifiée des présentes pour effectuer toutes formalités et faire

toutes déclarations, significations, dépôts, publications et autres.

Conformément aux dispositions de l'article 271 (2) de la Loi, le notaire soussigné atteste de la légalité du présent

Projet de Fusion établi en application des articles 261 et 278 de la Loi.

<i>Opposabilité à l'égard des tiers

Aux fins d'opposabilité de la Fusion à l'égard des tiers, tous pouvoirs sont donnés au Mandataire et au notaire soussigné

pour émettre un certificat conformément à l'article 273 (1) de la Loi, constatant que les conditions de l'article 279 sont
remplies, et pour procéder à la publication dudit certificat.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.
Le notaire instrumentaire, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparantes, le

présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction française. Il est spécifié qu'en cas de divergences entre
la version anglaise et la traduction française, le texte anglais fera foi.

Après lecture faite au Mandataire et interprétation donnée en une langue de lui connue, le Mandataire, connu du

notaire instrumentant par ses nom, prénom, état et demeure, a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Conde, Kesseler.

166458

L

U X E M B O U R G

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 14 novembre 2014. Relation: EAC/2014/15452. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2014178417/310.
(140204288) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2014.

Kanvass Furniture S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

R.C.S. Luxembourg B 191.202.

STATUTS

L'an deux mil quatorze, le seize octobre.
Par-devant Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

La société de droit luxembourgeoise Driedee International Group S.à r.l., ayant son siège social à 50 Esplanade, L-9227

Diekirch Luxembourg, inscrite auprès du registre de commerce sous le numéro B 183.647, représentée par son gérant
unique

Monsieur Herman Theo REUMERS né à Hasselt (Belgique) le 10 juin 1961, demeurant à B-3630 Maasmechelen, Aza-

lealaan (M) 4;

ci-après le "Comparant",
ici représenté par Madame Carina RODRIGUES, secrétaire, née à Luxembourg le 12 juillet 1990, demeurant profes-

sionnellement à L-9227 Diekirch, 50 Esplanade,

en vertu d'une procuration sous seing privé à elle délivrée à Luxembourg le 25 août 2014,
laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par la mandataire du "Comparant" et le notaire instrumentant,

resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront soumises aux formalités de l'enregistrement.

Lequel "Comparant", représenté comme ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser l'acte constitutif d'une

société à responsabilité limitée qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes par le "Comparant" et toutes les personnes qui pourraient devenir associés

par la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, et notamment celle du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (ci-après la "Société").

Art. 2. La société a pour objet le commerce d'articles d'ameublement.
Elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières et immobilières se rattachant

directement ou indirectement à son objet ou à tous objets similaires susceptibles d'en favoriser l'exploitation et le dé-
veloppement.

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, de participation ou autrement, dans toutes sociétés

et entreprises, existantes ou à créer, au Luxembourg ou à l'étranger et dont l'objet serait analogue ou connexe au sien.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La dissolution de la Société peut être demandée en justice pour justes motifs. Sauf dissolution judiciaire, la dissolution

de la Société ne peut résulter que d'une décision prise par l'assemblée générale dans les formes prescrites pour les
modifications des statuts.

Art. 4. La Société prend la dénomination sociale de Kanvass Furniture S.à r.l..

Art. 5. Le siège de la Société est établi dans la commune de Diekirch.
Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la même commune par simple décision du gérant ou, en cas de

pluralité de gérants, du Conseil de gérance, et en tout endroit du Grand Duché de Luxembourg aux termes d'une décision
prise par assemblée tenue dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.

La Société peut ouvrir des succursales, filiales ou d'autres bureaux, dans tout autre lieu du Grand-Duché de Luxem-

bourg, ainsi qu'à l'étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500,00 €) divisé en cent (100) parts sociales

d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,00 €) chacune, toutes les parts sociales étant intégralement souscrites
et entièrement libérées.

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision écrite et régulièrement publiée de

l'associé unique, sinon de l'assemblée des associés, conformément à l'article 16 des présents statuts.

166459

L

U X E M B O U R G

Art. 8. Chaque part sociale ouvre un droit à l'actif social de même qu'aux bénéfices réalisés au cours de l'exercice, en

proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un unique propriétaire pour chacune

d'elles.

Les copropriétaires indivis des parts sociales sont tenus d'être représentés auprès de la Société par une seule et même

personne.

Art. 10. Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seing privé.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale

des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont cessibles sous réserve de la stricte observation des dispositions

énoncées à l'article 189 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Toute opération de cession n'est opposable à la Société comme aux tiers qu'à la condition d'avoir été notifiée à la

Société ou acceptée par elle conformément aux dispositions prescrites à l'article 1690 du Code civil.

Au surplus, il ne pourra être contracté d'emprunt par voie publique d'obligations, ni procédé à une émission publique

de parts sociales.

Art. 11. La Société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un Conseil

de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocable(s) ad nutum.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, dispose des pouvoirs les plus étendus afin d'accomplir

tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la Société, à l'exception de ceux qui sont
expressément réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale des associés.

Art. 13. La Société sera engagée par la signature de son gérant, et en cas de pluralité de gérants, par la signature

conjointe de deux membres du Conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, peut sous-déléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Tout litige dans lequel la Société apparaît comme demandeur ou comme défendeur, sera géré au nom de la Société

par le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance représenté par un gérant délégué à cet effet.

Art. 14. Les réunions du Conseil de Gérance auront lieu au Grand-Duché de Luxembourg. Le Conseil de gérance ne

peut délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité de ses membres est présente en personne ou par procu-
ration. Les résolutions du Conseil de gérance sont adoptées à la majorité des votes des gérants présents ou représentés.

En cas d'urgence, les résolutions écrites signées par l'ensemble des membres du Conseil de gérance seront valablement

passées  et  effectives  comme  si  passées  lors  d'une  réunion  dûment  convenue  et  tenue.  De  telles  signatures  peuvent
apparaître sur un document unique ou plusieurs exemplaires d'une résolution identique et peuvent être prouvées par
lettre, fax ou communication similaire.

De plus, tout membre qui participe aux débats d'une réunion du Conseil de gérance aux moyens d'un appareil de

communication (notamment par téléphone), qui permet à tous les membres présent à cette réunion (que ce soit en
personne ou par procuration ou tout autre appareil de communication) d'entendre et d'être entendu par les autres
membres à tout moment, sera supposé être présent à cette réunion et sera comptabilisé pour le calcul du quorum et
sera autorisé à voter sur les questions à l'ordre du jour de cette réunion. Si une résolution est prise par voie de conférence
téléphonique, la résolution sera considérée comme ayant été prise au Luxembourg si l'appel provient initialement du
Luxembourg.

Art. 15. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Toutefois, la Société est liée par les actes accomplis par les gérants, même si ces actes excèdent l'objet social, à moins

qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des
circonstances, sans que la publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Art. 16. L'associé unique exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée des associés.
En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de

parts qui lui appartiennent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente. En cas de pluralité d'associés,

les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant
plus de la moitié du capital social, sans préjudice des autres dispositions de l'article 194 de la loi modifiée du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales.

Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que par l'accord de la majorité

des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

166460

L

U X E M B O U R G

Art. 17. Une assemblée générale annuelle des associés, qui doit se tenir au cas où la Société a plus de vingt-cinq (25)

associés, se réunira une fois par an pour l'approbation des comptes annuels, elle se tiendra le deuxième mardi du mois
de mai de chaque année au siège de la Société ou en tout autre lieu à spécifier dans la convocation de cette assemblée.

Si ce jour n'est pas généralement un jour bancaire ouvrable à Luxembourg, l'assemblée se tiendra le premier jour

ouvrable suivant.

Art. 18. L'année sociale de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque

année.

Art. 19. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le Conseil

de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

Tout associé peut par lui-même ou par un fondé de pouvoir, prendre au siège social de la Société, communication de

l'inventaire, du bilan et du rapport du conseil de surveillance (si la Société compte plus de vingt-cinq associés parmi ses
rangs, conformément aux dispositions prescrites par la loi).

Art. 20. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amor-

tissements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé au moins cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que

celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde du bénéfice net est à la libre disposition de l'assemblée générale.

Art. 21. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 22. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, l'associé unique, ou le cas échéant les associés, s'en

réfèrent aux dispositions légales de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation le premier exercice social commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2014.

<i>Souscription et libéralité

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, la comparante préqualifiée, représentée comme ci-avant, déclare

souscrire cent (100) parts sociales comme suit:

Driedee International Group S.à r.l., préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts
TOTAL: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts

La libération intégrale du capital social a été faite par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze

mille cinq cents euros (12.500,00 €) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire
soussigné, qui le constate expressément.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution au montant de neuf cents euros (900,00
€).

<i>Résolution des associés

Le Comparant préqualifié, représenté comme ci-avant, représentant l'intégralité du capital social souscrit, se consi-

dérant comme dûment convoqué, s'est ensuite constitué en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, le Comparant a pris les résolutions

suivantes:

1.- Le nombre des gérants est fixé à un (1).
2.- Est nommé gérant de la Société pour une durée indéterminée:
Monsieur Herman Theo REUMERS, Administrateur, né à Hasselt (Belgique) le 10 juin 1961, demeurant à B-3630

Maasmechelen, Azalealaan (M) 4.

La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature du gérant.
3.- L'adresse du siège social de la Société est fixée à L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

<i>Déclaration

Les associés déclarent que les fonds servant à la libération du capital ne proviennent pas, respectivement que l'objet

de la société à constituer ne couvre pas que la société se livre(ra) à des activités constituant une infraction visée aux
articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substance médicamen-
teuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-1 du code
Pénal (financement du terrorisme).

DONT ACTE, fait et passé à Ettelbruck, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.

166461

L

U X E M B O U R G

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire du Comparant, connue du notaire instrumentant par

noms, prénom usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Carina RODRIGUES, Pierre PROBST.
Enregistré à Diekirch, Le 17 octobre 2014. Relation: DIE/2014/13275. Reçu soixante-quinze euros 75,00.-€.

<i>Le Receveur pd (signé): Recken.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande et aux fins de publication au Mémorial.

Ettelbruck, le 23 octobre 2014.

Référence de publication: 2014164848/164.
(140187824) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2014.

La Financière Montbrillant S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 78.857.

Le Bilan au 31.12.2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014166455/10.
(140189841) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2014.

La Cuisine de Pékin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4141 Esch-sur-Alzette, 77, rue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg B 75.787.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour LA CUISINE DE PEKIN S.A.

Référence de publication: 2014166454/10.
(140189556) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2014.

Lear International Operations, Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.

R.C.S. Luxembourg B 168.316.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 22 octobre 2014

Il est décidé d'accepté la démission de Monsieur Luc HANSEN en tant que gérant de catégorie B.
Est nommé nouveau gérant de catégorie B avec effet immédiat et pour une durée indéterminée:
- Monsieur Philippe PONSARD, ingénieur commercial, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle,

L - 1653 Luxembourg.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 22 octobre 2014.

Référence de publication: 2014166442/15.
(140189729) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2014.

Matolux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 43.048.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014166509/9.
(140189317) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2014.

166462

L

U X E M B O U R G

Lux and Sole International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 81.018.

Le Bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 octobre 2014.

Chotin Barbara.

Référence de publication: 2014166478/10.
(140189919) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2014.

Liu-Lux S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9099 Ingeldorf, 1, rue du Cimetière.

R.C.S. Luxembourg B 117.734.

Le Bilan au 31.12.2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Joseph CANNIVY.

Référence de publication: 2014166469/10.
(140189384) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2014.

Lux-Sutures S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 22, Gruuss-Strooss.

R.C.S. Luxembourg B 104.042.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Wesiwampach, le 27 octobre 2014.

Signature.

Référence de publication: 2014166480/10.
(140189583) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2014.

Monitchem Holdco 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 187.111.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 octobre 2014.

Référence de publication: 2014166493/10.
(140189710) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2014.

Luxzelte S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6940 Niederanven, 162, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 153.024.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN S.à.r.l.
259 ROUTE D'ESCH
L-1471 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2014166481/13.
(140189824) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2014.

166463

L

U X E M B O U R G

LCO1 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 187.622.

Il y a lieu de noter que PRICEWATERHOUSECOOPERS S.À R.L, Société à responsabilité limitée, se trouve désormais

au 2 rue Gerhard Mercator L-2182 Luxembourg.

Fait à Luxembourg, le 22 octobre 2014.

Certifié sincère et conforme

Référence de publication: 2014166459/11.
(140189696) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2014.

NaturService S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5447 Schwebsange, 89, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 108.740.

Le bilan et l'annexe légale de l'exercice au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014166542/10.
(140189491) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2014.

NetOTC Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 164.493.

Les comptes annuels de la société NetOTIC Holdings S.à.r.l. au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014166544/10.
(140189980) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2014.

New Landscape S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 17, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 151.470.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 69500 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014166545/10.
(140190010) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2014.

Naxamber S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 160.458.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 octobre 2014.

Référence de publication: 2014166553/10.
(140189884) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2014.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

166464


Document Outline

Coveris Holdings S.A.

Eifel Management S.à r.l. &amp; Partners S.C.A.

Eifel S.à r.l.

Elite S.à r.l.

Epinay S.A.

Epinay S.A.

Eprec S.A.

Eraulux

Esaf International Management

Espirito Santo Industrial S.A.

Esther Invest S.A.

Euro Capital Markets Luxemburg S.A.

Europa (Lux) S.à r.l.

Exportcars s.à r.l.

Faccino SA

Fashion House Group S.à r.l.

Fiduciaire SMC Luxembourg, Société Civile

Financière Epeios S.A.

Fintax

Firstluxe S.A.

Fiusari S.A. SPF

Fondation Alphonse WEICKER

Fortum Finance Ireland Limited Luxembourg Branch

Fosun Luxembourg Holdings S.à r.l.

Free Record Shop Luxembourg S.à r.l.

FR Horizon Topco Sàrl

Garden Consult

Garden Properties S.à r.l.

Garibaldi Holdings S.à r.l.

Gemat Grue Service S.A.

Gläsener Transports S. à r. l.

Global Indemnity (Luxembourg) S.à r.l.

Gopal S.A.

Governance People S.A.

Group La Perla Living S.à r.l.

Investec Asset Management Luxembourg S.A.

I/O Luxembourg S.à r.l.

Kanvass Furniture S.à r.l.

La Cuisine de Pékin S.A.

La Financière Montbrillant S.A.

LCO1 S.A.

Lear International Operations

Liu-Lux S.à.r.l.

Lux and Sole International S.A.

Lux-Sutures S.A.

Luxzelte S.à r.l.

Matolux S.A.

Monitchem Holdco 1 S.à r.l.

NaturService S.à r.l.

Naxamber S.A.

NetOTC Holdings S.à r.l.

New Landscape S.A.

Odyssey Opportunities 17 S.à r.l.

Primos S.A.

Profima S.A.

Swiss Life Funds (Lux) Global Infrastructure Opportunities S.C.A., SICAV-SIF