This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 3387
14 novembre 2014
SOMMAIRE
Advanced Asset Management SICAV . . . .
162576
Asia Internet Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
162540
BRE/Management 2 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
162532
BRE/Management 3 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
162534
BRE/Management 4 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
162531
BRE/Management 5 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
162533
BRE/Management 6 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
162533
BRE/Management S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
162531
Castle U.S. Corporate Bonds Fund . . . . . .
162537
Colada HoldCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
162539
Cole Objekt Düsseldorf GmbH . . . . . . . . . .
162570
Cole Objekt Theresienhöhe GmbH . . . . . .
162570
Deutsche Invest I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
162530
Deutsche Invest I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
162530
Deutsche Invest I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
162533
Deutsche Invest I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
162530
Deutsche Invest I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
162534
Deutsche Invest I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
162535
Deutsche Invest I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
162530
Deutsche Invest I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
162533
DWS Institutional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
162535
DWS Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
162532
Finaries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
162574
Harbour LuxCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
162535
HLSS Luxco 2A S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
162535
HSBC Securities Services (Luxembourg)
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
162556
Immobilière Schockweiler & Bäumler S.à
r.l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
162534
Infotech Project S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
162530
Langley LuxCo 1 S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
162536
LBLux SICAV-FIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
162537
Muha LuxCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
162562
MUTB Non-Yen WGBI Yen-Hedged Index
Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
162536
Observe LuxCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
162538
Premium Portfolio SICAV . . . . . . . . . . . . . .
162538
Rice LuxCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
162561
Saddle Luxco Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
162561
Saturno S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
162559
Signes S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
162539
Swiss Alpha, SICAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
162531
Tarpan LuxCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
162536
Timberland, SICAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
162532
Triton III LuxCo 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
162540
Triton III LuxCo 8 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
162534
Triton III LuxCo 9 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
162561
Triton III LuxCo A 16 S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
162538
Veresen Finance S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
162562
Way LuxCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
162536
World Investments Company, en abrégé
WIC S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
162559
162529
L
U X E M B O U R G
Deutsche Invest I, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 86.435.
Der Teilfonds DWS Invest DYMOND wurde am 30. Juli 2013 liquidiert.
Der Liquidationsprozess ist abgeschlossen. Die State Street Bank Luxembourg S.A., in ihrer Funktion als Depotbank,
hat das Teilfondsvermögen an die Anteilinhaber ausgezahlt. Es wurden keine Beträge an die Caisse de Consignation
überwiesen.
Luxemburg, im Oktober 2014
Référence de publication: 2014176634/1999/11.
Deutsche Invest I, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 86.435.
Der Teilfonds DWS Invest Sovereigns Plus wurde am 09. April 2013 liquidiert.
Der Liquidationsprozess ist abgeschlossen. Die State Street Bank Luxembourg S.A., in ihrer Funktion als Depotbank,
hat das Teilfondsvermögen an die Anteilinhaber ausgezahlt. Es wurden keine Beträge an die Caisse de Consignation
überwiesen.
Luxemburg, im Oktober 2014
Référence de publication: 2014176631/1999/11.
Deutsche Invest I, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 86.435.
Der Teilfonds DWS Invest Small/Mid Cap Value wurde am 27. Juni 2013 liquidiert.
Der Liquidationsprozess ist abgeschlossen. Die State Street Bank Luxembourg S.A., in ihrer Funktion als Depotbank,
hat das Teilfondsvermögen an die Anteilinhaber ausgezahlt. Es wurden keine Beträge an die Caisse de Consignation
überwiesen.
Luxemburg, im Oktober 2014
Référence de publication: 2014176630/1999/11.
Deutsche Invest I, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 86.435.
Die Anteilklasse E1Q des Teilfonds DWS Invest RREEF Global Real Estate Securities (ab 25.08.2014: Deutsche Invest
I RREEF Global Real Estate Securities) wurde am 23. Mai 2013 liquidiert.
Der Liquidationsprozess ist abgeschlossen. Die State Street Bank Luxembourg S.A., in ihrer Funktion als Depotbank,
hat das Teilfondsvermögen an die Anteilinhaber ausgezahlt. Es wurden keine Beträge an die Caisse de Consignation
überwiesen.
Luxemburg, im Oktober 2014
Référence de publication: 2014176635/1999/12.
Infotech Project S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 111.691.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014164043/9.
(140186901) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2014.
162530
L
U X E M B O U R G
BRE/Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 96.323.
EXTRAIT
Il résulte de résolutions écrites de l'actionnaire unique de la Société prises en date du 7 novembre 2014 que:
- Le siège social de la Société est transféré au 35, Avenue Monterey L-2163 Luxembourg;
- Il a été mis fin au mandat de commissaire aux comptes de EURAUDIT S.à r.l.;
- Mme Karin Wagener, née le 4 juin 1977 à Malmedy, Belgique, avec adresse professionnelle au 35, Avenue Monterey,
L-2163 Luxembourg a été nommée, pour une durée de six ans, en tant que commissaire aux comptes de la Société.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
<i>Pour BRE/Management S.A.i>
Référence de publication: 2014173487/15.
(140198634) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.
BRE/Management 4 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 151.599.
EXTRAIT
Il résulte de résolutions écrites de l'actionnaire unique de la Société prises en date du 7 novembre 2014 que:
- Le siège social de la Société est transféré au 35, Avenue Monterey L-2163 Luxembourg;
- Il a été mis fin au mandat de commissaire aux comptes de EURAUDIT S.à r.l.;
- Mme Karin Wagener, née le 4 juin 1977 à Malmedy, Belgique, avec adresse professionnelle au 35, Avenue Monterey,
L-2163 Luxembourg a été nommée, pour une durée de six ans, en tant que commissaire aux comptes de la Société.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
<i>Pour BRE/Management 4 S.A.i>
Référence de publication: 2014173490/15.
(140198698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.
Swiss Alpha, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 3, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 148.588.
Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit laden wir Sie zu einer
AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
des Swiss Alpha, SICAV am <i>2. Dezember 2014i> um 10:00 Uhr, in den Geschäftsräumen der Banque LBLux am Sitz der
Gesellschaft, 3, rue Jean Monnet, L- 2180 Luxemburg ein.
Als Tagesordnungspunkt wurde vorgeschlagen:
• 1. Verlegung des Sitzes der Gesellschaft
vorher
nachher
Ab dem 22.12.2014
3, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg
6, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Muns-
bach
2. Sonstiges
Zur Teilnahme an der außerordentlichen Generalversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen
Aktionäre berechtigt, die bis spätestens 28. November 2014 die Depotbestätigung eines Kreditinstituts bei der Gesell-
schaft einreichen aus der hervorgeht, dass die Aktien bis zur Beendigung der Generalversammlung gesperrt gehalten
werden. Aktionäre können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevollmächtigt ist.
Es besteht ein Quorum für die außerordentliche Generalversammlung. Die außerordentliche Generalversammlung ist
nur dann beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten ist.
<i>Der Verwaltungsrat.i>
Référence de publication: 2014175800/24.
162531
L
U X E M B O U R G
Timberland, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 3, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 161.772.
Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit laden wir Sie zu einer
AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
des Timberland, SICAV am <i>2. Dezember 2014i> um 9:30 Uhr, in den Geschäftsräumen der Banque LBLux am Sitz der
Gesellschaft, 3, rue Jean Monnet, L- 2180 Luxemburg ein.
Als Tagesordnungspunkt wurde vorgeschlagen:
• 1. Verlegung des Sitzes der Gesellschaft
vorher
nachher
Ab dem 22.12.2014
3, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg
6, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Muns-
bach
2. Sonstiges
Zur Teilnahme an der außerordentlichen Generalversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen
Aktionäre berechtigt, die bis spätestens 28. November 2014 die Depotbestätigung eines Kreditinstituts bei der Gesell-
schaft einreichen aus der hervorgeht, dass die Aktien bis zur Beendigung der Generalversammlung gesperrt gehalten
werden. Aktionäre können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevollmächtigt ist.
Es besteht ein Quorum für die außerordentliche Generalversammlung. Die außerordentliche Generalversammlung ist
nur dann beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten ist.
<i>Der Verwaltungsrat.i>
Référence de publication: 2014175801/24.
DWS Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 25.754.
Die oben genannten Fonds wurden zu den nachstehend aufgeführten Daten liquidiert:
PWM Mandat - DWS - Institutional Innovation R3
24. Juni 2014
DWS Dividende Direkt 2014
30. Juni 2014
DWS FlexPension I
30. Juni 2014
DWS Renten Direkt 2014 II
19. September 2014
Die Liquidationsprozesse sind abgeschlossen. Die State Street Bank Luxembourg S.A., in ihrer Funktion als Depotbank,
hat das jeweilige Fondsvermögen an die Anteilinhaber ausgezahlt. Es wurden keine Beträge an die Caisse de Consignation
überwiesen.
Luxemburg, im Oktober 2014
Référence de publication: 2014176632/1999/15.
BRE/Management 2 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 151.596.
EXTRAIT
Il résulte de résolutions écrites de l'actionnaire unique de la Société prises en date du 7 novembre 2014 que:
- le siège social de la Société est transféré au 35, Avenue Monterey L-2163 Luxembourg;
- il a été mis fin au mandat de commissaire aux comptes de EURAUDIT S.à r.l.;
- Mme Karin Wagener, née le 4 juin 1977 à Malmedy, Belgique, avec adresse professionnelle au 35, Avenue Monterey,
L-2163 Luxembourg a été nommée, pour une durée de six ans, en tant que commissaire aux comptes de la Société.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
<i>Pour BRE/Management 2 S.A.i>
Référence de publication: 2014173488/15.
(140198708) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.
162532
L
U X E M B O U R G
BRE/Management 5 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 151.600.
EXTRAIT
Il résulte de résolutions écrites de l’actionnaire unique de la Société prises en date du 7 novembre 2014 que:
- le siège social de la Société est transféré au 35, Avenue Monterey L-2163 Luxembourg;
- il a été mis fin au mandat de commissaire aux comptes de EURAUDIT S.à r.l.;
- Mme Karin Wagener, née le 4 juin 1977 à Malmedy, Belgique, avec adresse professionnelle au 35, Avenue Monterey,
L-2163 Luxembourg a été nommée, pour une durée de six ans, en tant que commissaire aux comptes de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour BRE/Management 5 S.A.i>
Référence de publication: 2014173491/15.
(140198888) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.
BRE/Management 6 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 164.777.
EXTRAIT
Il résulte de résolutions écrites de l'actionnaire unique de la Société prises en date du 7 novembre 2014 que:
- le siège social de la Société est transféré au 35, Avenue Monterey L-2163 Luxembourg;
- il a été mis fin au mandat de commissaire aux comptes de EURAUDIT S.à r.l.;
- Mme Karin Wagener, née le 4 juin 1977 à Malmedy, Belgique, avec adresse professionnelle au 35, Avenue Monterey,
L-2163 Luxembourg a été nommée, pour une durée de six ans, en tant que commissaire aux comptes de la Société.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
<i>Pour BRE/Management 6 S.A.i>
Référence de publication: 2014173492/15.
(140198679) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.
Deutsche Invest I, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 86.435.
Die Anteilklasse A2H des Teilfonds DWS Invest Top Euroland (ab 25.08.2014: Deutsche Invest I Top Euroland) wurde
am 30. Juli 2013 liquidiert.
Der Liquidationsprozess ist abgeschlossen. Die State Street Bank Luxembourg S.A., in ihrer Funktion als Depotbank,
hat das Teilfondsvermögen an die Anteilinhaber ausgezahlt. Es wurden keine Beträge an die Caisse de Consignation
überwiesen.
Luxemburg, im Oktober 2014
Référence de publication: 2014176636/1999/12.
Deutsche Invest I, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 86.435.
Die Anteilklasse FD des Teilfonds DWS Invest Global Thematic (ab 25.08.2014: Deutsche Invest I Global Thematic)
wurde am 19. September 2013 liquidiert.
Der Liquidationsprozess ist abgeschlossen. Die State Street Bank Luxembourg S.A., in ihrer Funktion als Depotbank,
hat das Teilfondsvermögen an die Anteilinhaber ausgezahlt. Es wurden keine Beträge an die Caisse de Consignation
überwiesen.
Luxemburg, im Oktober 2014
Référence de publication: 2014176633/1999/12.
162533
L
U X E M B O U R G
Deutsche Invest I, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 86.435.
Die Anteilklasse A2 des Teilfonds DWS Invest Global Value wurde am 11. Juli 2013 liquidiert.
Der Liquidationsprozess ist abgeschlossen. Die State Street Bank Luxembourg S.A., in ihrer Funktion als Depotbank,
hat das Teilfondsvermögen an die Anteilinhaber ausgezahlt. Es wurden keine Beträge an die Caisse de Consignation
überwiesen.
Luxemburg, im Oktober 2014
Deutsche Invest I, SICAV
Référence de publication: 2014176637/1999/12.
Immobilière Schockweiler & Bäumler S.à r.l, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6947 Niederanven, 10-12, Z.I. Bombicht.
R.C.S. Luxembourg B 187.536.
RECTIFICATIF
Il y a lieu de rectifier comme suit la première ligne de l'en-tête de la publication dans le Mémorial C n° 2123 du 11
août 2014, page 101881:
au lieu de:
"Immobilière Schockweiler & Bäumler S.à r.l, Société Anonyme Unipersonelle.",
lire :
"Immobilière Schockweiler & Bäumler S.à r.l, Société à responsabilité limitée."
Référence de publication: 2014175802/13.
Triton III LuxCo 8 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 155.493.
RECTIFICATIF
Il y a lieu de rectifier comme suit, dans le Mémorial C n° 2623 du 27 septembre 2014, page 125863:
Premier paragraphe au point 3, troisième tiret:
au lieu de:
"- Monsieur Matthew Orili, .....",
lire:
"- Monsieur Matthew Crill, ......".
Référence de publication: 2014175806/14.
BRE/Management 3 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 151.598.
EXTRAIT
Il résulte de résolutions écrites de l'actionnaire unique de la Société prises en date du 7 novembre 2014 que:
- le siège social de la Société est transféré au 35, Avenue Monterey L-2163 Luxembourg;
- il a été mis fin au mandat de commissaire aux comptes de EURAUDIT S.à r.l..
- Mme Karin Wagener, née le 4 juin 1977 à Malmedy, Belgique, avec adresse professionnelle au 35, Avenue Monterey,
L-2163 Luxembourg a été nommée, pour une durée de six ans, en tant que commissaire aux comptes de la Société.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
<i>Pour BRE/Management 3 S.A.i>
Référence de publication: 2014173489/15.
(140198701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.
162534
L
U X E M B O U R G
DWS Institutional, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 38.660.
Der Teilfonds DWS Institutional Euro Collateralized Bonds wurde am 26. Mai 2014 liquidiert.
Der Liquidationsprozess ist abgeschlossen. Die State Street Bank Luxembourg S.A., in ihrer Funktion als Depotbank,
hat das Teilfondsvermögen an die Anteilinhaber ausgezahlt. Es wurden keine Beträge an die Caisse de Consignation
überwiesen.
Luxemburg, im Oktober 2014
Référence de publication: 2014176638/1999/11.
Deutsche Invest I, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 86.435.
Der Teilfonds DWS Concept ets wurde am 28. November 2013 liquidiert.
Der Liquidationsprozess ist abgeschlossen. Die State Street Bank Luxembourg S.A., in ihrer Funktion als Depotbank,
hat das Teilfondsvermögen an die Anteilinhaber ausgezahlt. Es wurden keine Beträge an die Caisse de Consignation
überwiesen.
Luxemburg, im Oktober 2014
Deutsche Invest I, SICAV
Référence de publication: 2014176639/1999/12.
Harbour LuxCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 18.027,88.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 159.677.
RECTIFICATIF
Il y a lieu de rectifier comme suit, dans le Mémorial C n° 2652 du 1
er
octobre 2014, page 127296:
Premier paragraphe au point 2, troisième tiret:
au lieu de:
"- Monsieur Matthew Orili, .....",
lire:
"- Monsieur Matthew Crill, ......".
Référence de publication: 2014175812/14.
HLSS Luxco 2A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 90.322.800,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 180.934.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 29 août 2014i>
1. Madame Nicola FOLEY a démissionné de son mandat de gérante B avec effet au 29 août 2014.
2. Monsieur Davy Toussaint, administrateur de sociétés, né le 28 Octobre 1986 à Bastogne (Belgique), demeurant
professionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommé comme gérant B pour une durée
indéterminée avec effet au 29 août 2014.
Luxembourg, le 18 septembre 2014.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Hlss Luxco 2a S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.
Référence de publication: 2014164009/17.
(140187139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2014.
162535
L
U X E M B O U R G
Tarpan LuxCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,06.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 151.878.
RECTIFICATIF
Il y a lieu de rectifier comme suit, dans le Mémorial C n° 2631 du 29 septembre 2014, page 126253:
Premier paragraphe au point 2, troisième tiret:
au lieu de:
"- Monsieur Matthew Orili, .....",
lire:
"- Monsieur Matthew Crill, ......".
Référence de publication: 2014175816/14.
Langley LuxCo 1 S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.502,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 178.308.
RECTIFICATIF
Il y a lieu de rectifier comme suit, dans le Mémorial C n° 2662 du 1
er
octobre 2014, page 127739:
Premier paragraphe au point 2, troisième tiret:
au lieu de:
"- Monsieur Matthew Grill, .....",
lire:
"- Monsieur Matthew Crill, ......".
Référence de publication: 2014175813/14.
Way LuxCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,04.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 151.888.
RECTIFICATIF
Il y a lieu de rectifier comme suit, dans le Mémorial C n° 2677 du 2 octobre 2014, page 128456:
Premier paragraphe au point 2, troisième tiret:
au lieu de:
"- Monsieur Matthew Orili, .....",
lire:
"- Monsieur Matthew Crill, ......".
Référence de publication: 2014175808/14.
MUTB Non-Yen WGBI Yen-Hedged Index Fund, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement
Spécialisé.
Le règlement de gestion modifié de MUTB NON-YEN WGBI YEN-HEDGED INDEX FUND a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 novembre 2014.
MUGC Lux Management S.A.
Signature
Référence de publication: 2014173923/12.
(140198472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.
162536
L
U X E M B O U R G
LBLux SICAV-FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 3, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 132.782.
Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit laden wir Sie zu einer
AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
des LBLux SICAV-FIS am <i>2. Dezember 2014i> um 9.00 Uhr, in den Geschäftsräumen der Banque LBLux am Sitz der
Gesellschaft, 3, rue Jean Monnet, L- 2180 Luxemburg ein.
Als Tagesordnungspunkt wurde vorgeschlagen:
• 1. Satzungsänderung
vorher
nachher
Art. 21. Absatz 2
Kosten
Die Depotbank berechnet Depotbank-
gebühren. Diese Depotbankgebühren
beinhalten in der Regel alle fremden
Verwahrungs- und Verwaltungsgebüh-
ren, die von anderen Korrespondenz-
banken und/ oder Clearingstellen (z.B.
Clearstream oder Euroclear) für die
Verwahrung der Vermögenswerte der
Gesellschaft in Rechnung gestellt wer-
den.
Des Weiteren erhält die Depotbank aus
dem Vermögen eines jeden Teilfonds ei-
ne bankenübliche Umsatzprovision auf
jede Wertpapiertransaktion an einer öf-
fentlichen Börse oder im Freiverkehr;
Die Depotbank berechnet eine jährliche
Depotbankgebühr von bis zu 0,7%, zahl-
bar monatlich, berechnet auf den letzten
Nettoinventarwert eines jeden Teil-
fonds am Ende eines jeden Monats.
Fremde Verwahrungs- und Verwal-
tungsgebühren, die von anderen Kor-
respondenzbanken und/oder Clearing-
stellen (z.B. Clearstream oder Eurocle-
ar) für die Verwahrung der Vermögens-
werte des Fonds anfallen, werden dem
Fondvermögen gesondert in Rechnung
gestellt.
2. Verlegung des Sitzes der Gesellschaft
vorher
nachher
Ab dem 22.12.2014
3, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg
6, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Muns-
bach
3. Sonstiges
Zur Teilnahme an der außerordentlichen Generalversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen
Aktionäre berechtigt, die bis spätestens 28. November 2014 die Depotbestätigung eines Kreditinstituts bei der Gesell-
schaft einreichen aus der hervorgeht, dass die Aktien bis zur Beendigung der Generalversammlung gesperrt gehalten
werden. Aktionäre können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevollmächtigt ist.
Es besteht ein Quorum für die außerordentliche Generalversammlung. Die außerordentliche Generalversammlung ist
nur dann beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten ist.
<i>Der Verwaltungsrat.i>
Référence de publication: 2014175799/43.
Castle U.S. Corporate Bonds Fund, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 49.759.
Le règlement de gestion modifié de CASTLE U.S. CORPORATE BONDS FUND a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 novembre 2014.
MUGC Lux Management S.A.
Signature
Référence de publication: 2014173921/13.
(140198470) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.
162537
L
U X E M B O U R G
Triton III LuxCo A 16 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 159.683.
RECTIFICATIF
Il y a lieu de rectifier comme suit, dans le Mémorial C n° 2713 du 3 octobre 2014, page 130224:
Premier paragraphe au point 3, troisième tiret:
au lieu de:
"- Monsieur Matthew Grill, .....",
lire:
"- Monsieur Matthew Crill, ......".
Deuxième paragraphe, deuxième ligne de la composition du conseil de gérance:
au lieu de:
"- Monsieur Matthew Criil, gérant de catégorie B",
lire:
"- Monsieur Matthew Grifi, gérant de catégorie B".
Référence de publication: 2014175807/19.
Observe LuxCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: SEK 120.210,40.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 144.039.
RECTIFICATIF
Il y a lieu de rectifier comme suit, dans le Mémorial C n° 2631 du 29 septembre 2014, page 126253:
Premier paragraphe au point 2, troisième tiret:
au lieu de:
"- Monsieur Matthew Grill, .....",
lire:
"- Monsieur Matthew Crill, ......".
Deuxième paragraphe, quatrième ligne de la composition du conseil de gérance:
au lieu de:
"- Monsieur Matthew Orili, gérant de catégorie B",
lire:
"- Monsieur Matthew Crill, gérant de catégorie B".
Référence de publication: 2014175815/19.
Premium Portfolio SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 137.056.
Mitteilung an die Aktionäre des Teilfonds
Premium Portfolio SICAV - Multi Trend Plus
(Anteilklasse R: WKN: A0M8H1; ISIN: LU0329744063)
Hiermit werden die Aktionäre des Teilfonds Premium Portfolio SICAV - Multi Trend Plus ("Teilfonds") der Invest-
mentgesellschaft Premium Portfolio SICAV darüber informiert, dass der Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft in
Übereinstimmung mit Artikel 7 der Satzung die Liquidation des Teilfonds am 31. Dezember 2014 hat.
Hintergrund der Liquidation ist, dass das Teilfondsvolumen in naher Zukunft auf einen Betrag sinken wird, der eine
wirtschaftlich effiziente Verwaltung des Teilfonds im Sinne der Aktionäre nicht mehr gewährleistet.
Um die Gleichbehandlung aller Aktionäre zu gewährleisten, wurden die Ausgaben und Rücknahmen der Aktien des
Teilfonds ab dem 04. November 2014 (17:00 Uhr) ausgesetzt. Der Nettoinventarwert wird bis zur Durchführung der
Liquidation weiterhin täglich berechnet und veröffentlicht.
162538
L
U X E M B O U R G
Die mit der Liquidation verbundenen Kosten trägt der Teilfonds.
Die Netto-Liquidationserlöse deren Empfänger nicht erreicht werden, werden von der Depotbank nach Abschluss des
Liquidationsverfahrens für Rechnung der Anleger bei der Caisse de Consignation hinterlegt, wo diese Beträge verfallen,
wenn sie nicht innerhalb der gesetzlichen Frist angefordert werden.
Luxemburg, im November 2014
Der Verwaltungsrat
Référence de publication: 2014176627/755/23.
Colada HoldCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.504,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 159.678.
RECTIFICATIF
Il y a lieu de rectifier comme suit, dans le Mémorial C n° 3060 du 22 octobre 2014, page 146851:
Premier paragraphe au point 2, troisième tiret:
au lieu de:
"- Monsieur Matthew Grill, .....",
lire:
"- Monsieur Matthew Crill, ......".
Deuxième paragraphe, quatrième ligne de la composition du conseil de gérance:
au lieu de:
"- Monsieur Matthew Grill, gérant de catégorie B",
lire:
"- Monsieur Matthew Crill, gérant de catégorie B".
Référence de publication: 2014175809/19.
Signes S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 79.475.
L'an deux mille quatorze, le vingt-six septembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU
Monsieur Eric BIREN, directeur de société, avec adresse professionnelle au 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320
Luxembourg,
Laquelle partie comparante est l'associé unique de «SIGNES S.à.r.l.» (ci après la "Société"), une société à responsabilité
limitée ayant son siège social au 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg B 79475, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du
13 décembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 521 du 11 juillet 2001. Les statuts
ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 15 décembre 2011, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 1047 du 24 avril 2012.
Laquelle partie comparante, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'associé unique décide de convertir les cent vingt-cinq (125) parts sociales existantes de la Société ayant une valeur
nominale de cents euros (100 EUR) chacune contre cent vingt-cinq mille (125.000) parts sociales ayant une valeur nominale
de dix centimes d'euros (0,10 EUR) chacune.
Tous pouvoirs sont conférés au gérant de la Société pour procéder à la conversion des anciennes parts sociales contre
les nouvelles parts sociales.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence des résolutions précédentes, l'article 6 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
Art. 6. «Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500.- EUR), représenté par cent vingt-cinq mille
(125.000) parts sociales ayant une valeur nominale de dix centimes d'euros (0,10 EUR) chacune.»
162539
L
U X E M B O U R G
Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, le comparant prémentionné a signé avec le notaire le présent
acte.
Signé: E. BIREN, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 02 octobre 2014. Relation: EAC/2014/13292. Reçu soixante-quinze Euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Monique HALSDORF.
Référence de publication: 2014160521/37.
(140182455) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2014.
Triton III LuxCo 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 151.877.
RECTIFICATIF
Il y a lieu de rectifier comme suit, dans le Mémorial C n° 2957 du 15 octobre 2014, page 141910:
Premier paragraphe au point 3, troisième tiret:
au lieu de:
"- Monsieur Matthew Grill, .....",
lire:
"- Monsieur Matthew Crill, ......".
Deuxième paragraphe, deuxième ligne de la composition du conseil de gérance:
au lieu de:
"- Monsieur Matthew Grill, gérant de catégorie B",
lire:
"- Monsieur Matthew Grifi, gérant de catégorie B".
Référence de publication: 2014175805/19.
Asia Internet Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 50.000,00.
Siège social: L-2324 Luxembourg, 7, avenue Pescatore.
R.C.S. Luxembourg B 177.038.
In the year two thousand and fourteen, on the twenty-eighth day of August.
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
1. Rocket Internet AG (formerly Rocket Internet GmbH), a stock corporation (Aktiengesellschaft) existing under the
laws of Germany with its statutory seat in Berlin, Germany, registered with the commercial register (Handelsregister) at
the local court of Charlottenburg (Amtsgericht Charlottenburg), Germany, under no. HRB 159634 B, having its business
address at Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Germany, (“Rocket”),
being the holder of twenty-five thousand (25,000) shares of the Company,
here represented by Mr Philippe Sylvestre, Maître en droit, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy,
given in Berlin, Germany, on 31 July 2014;
2. Al Wokaer Holding S.P.C., a single person company incorporated under the laws of the Kingdom of Bahrain, re-
gistered with the Ministry of Industry & Commerce of the Kingdom of Bahrain under registration number 87226-1,
(hereinafter “AI Wokaer”), participating and voting only for purposes of Agenda point 3 et seqq.,
becoming the holder of twenty-five thousand (25,000) shares of the Company,
here represented by Mr Philippe Sylvestre, Maître en droit, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy,
given in Singapore on 27 August 2014.
The said proxies, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary will remain annexed
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Rocket is the sole shareholder of Asia Internet Holding S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and
existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 7, avenue Pescatore, L-2324
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 177.038 and incorporated
pursuant to a deed of the undersigned notary on 19 April 2013, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et
162540
L
U X E M B O U R G
Associations number 1518 dated 26 June 2013. The articles of association were amended for the last time pursuant to a
deed of the notary Maître Marc Loesch, residing in Mondorf-les-Bains, on 4 April 2014, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations number 1747 dated 5 July 2014.
Rocket representing the entire share capital and having waived any notice requirement, the general meeting of sha-
reholders is regularly constituted and may validly deliberate on the following agenda whereby AI Wokaer participates
and votes for purpose of Agenda point 3 et seqq. only:
<i>Agendai>
1. Acceptance of Al Wokaer Holding S.P.C a single person company incorporated under the laws of the Kingdom of
Bahrain, registered with the Ministry of Industry & Commerce of the Kingdom of Bahrain under registration number
87226-1, as new shareholder of the Company.
2.Increase of the Company’s share capital by an amount of twenty-five thousand euro (EUR 25,000) so as to raise it
from its current amount of twenty-five thousand euro (EUR 25,000) up to fifty thousand euro (EUR 50,000) by issuing
twenty-five thousand (25,000) shares with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each.
3. Subsequent amendment of article five (5) of the articles of association of the Company so that it shall henceforth
read as follows:
« Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company’s share capital is set at fifty thousand Euros (EUR 50,000.00) represented by fifty thousand (50,000)
shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each.
The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by these
articles of association or by the Law.
5.2 The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.”
4. Full restatement of the articles of association of the Company so that they shall henceforth read as follows:
A.“Name - Purpose - Duration - Registered office
Art. 1. Name. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name Asia
Internet Holding S.à r.l. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning
commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.
Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign
companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio.
2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it
holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the
Company.
2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by
issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.
2.4 The purpose of the Company is also (i) the acquisition by purchase, registration or in any other manner as well as
the transfer by sale, exchange or otherwise of intellectual and industrial property rights, (ii) the granting of license on
such intellectual and industrial property rights, and (iii) the holding and the management of intellectual and industrial
property rights.
2.5 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities
which it considers useful for the accomplishment of these purposes, in view of its realisation by sale, exchange or other-
wise.
Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time with or without cause by a resolution of the general meeting of the shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
Art. 4. Registered Office.
4.1 The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by decision of the board of managers. It
may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by resolution of the general meeting
of the shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution
of the board of managers.
162541
L
U X E M B O U R G
4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances
or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
traordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwiths-
tanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.
B. Share capital - Shares
Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company’s share capital is set at fifty thousand Euros (EUR 50,000.00) represented by fifty thousand (50,000)
shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each.
The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by these
articles of association or by the Law.
5.2 The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
Art. 6. Shares.
6.1 The Company’s share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of
the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.
6.5 The Company may accept contributions without issuing shares or other securities in consideration and may allocate
such contributions to one or more distributable reserves. Decisions as to the use of any such distributable reserves are
to be taken by the shareholder(s) or the manager(s) as the case may be, subject to the Law and these articles of association.
Art. 7. Register of Shares - Transfer of Shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection
by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.
7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall
appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.
7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the unanimous approval of such
transfer given by all shareholders except for any transfers identified as such in any shareholders’ agreement entered into
between the shareholders from time to time, if any, in particular, any rights of first refusal, rights of pre-emption or tag-
along rights or drag-along rights contained in any shareholders’ agreement entered into between the shareholders from
time to time, it being understood that the Super Majority (as defined below) consent will always be required.
7.5 Article 7.4 shall apply accordingly to the conclusion of fiduciary relationships, pledge agreements, the grant of sub-
participations, the assignment and setting off of claims and rights derived from shares in the Company, in particular, all
claims for payment of profits, except for the conclusion of pledge agreements with and the assignment of claims to banks
in connection with external financing agreements; these are subject to the voting agreement pursuant to 7.4 above.
7.6 Any transfer, assignment or any other disposal of shares shall become effective towards the Company and third
parties through the notification of the transfer, assignment or any other disposal to, or upon the acceptance of the transfer,
assignment or any other disposal by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.
7.7 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject
to the approval of such transfer given by a majority of shareholders holding at least three quarters of the share capital (a
“Super Majority”) (which, for these purposes, shall exclude the shares of the deceased shareholder). Such approval is,
however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse or any
other legal heir of the deceased shareholder.
C. Decisions of the shareholders
Art. 8. Collective decisions of the shareholders.
8.1 The general meeting of the shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by applicable law and
by these articles of association.
8.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
8.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise
conferred on the general meeting of the shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case,
each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his
vote in writing.
162542
L
U X E M B O U R G
8.4 The shareholders’ resolutions are passed in meetings. Unless mandatory law prescribes another form, they can
also be passed outside meetings in writing (including e-mail) or telephone voting if such procedure is requested by a
shareholder and no other shareholder declares its dissent with the procedure within two (2) weeks towards the board
of managers of the Company in written form. If no dissent is declared within the two (2) weeks pursuant to the foregoing
sentence the votes of the shareholders which are not participating in the voting shall be deemed to be abstention from
voting. Written resolutions must be signed by each shareholder and the written record must be sent to each shareholder
without undue delay. Resolutions not passed in writing must be confirmed in writing. Such confirmation only has decla-
ratory significance.
8.5 Unless a notarial record is made of the shareholders’ resolutions, a written record must be made of every resolution
passed at general meetings of the shareholders (for purposes of proof, not as a precondition of validity) without undue
delay, which must state the date and form of the resolution passed, the content of the resolution and the votes cast. The
written record must be sent to each shareholder in writing without undue delay.
8.6 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of
the shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any
reference made herein to the “general meeting of the shareholders” shall be construed as a reference to the sole sha-
reholder, depending on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of the shareholders
shall be exercised by the sole shareholder.
Art. 9. General meetings of the shareholders.
9.1 General meetings of the shareholders may be held at the registered office of the Company or at such place and
time as may be specified in the respective convening notices of meeting.
9.2 The general meeting of the shareholders is called by registered letter (registered personal delivery, registered
delivery or registered letter with confirmation of receipt) to each shareholder, stating the place, date, time and agenda,
with a period of notice of at least four (4) weeks for ordinary general meetings of the shareholders and at least two (2)
weeks for extraordinary general meetings of the shareholders. The period of notice begins to run on the day following
postage. The day of the general meeting of the shareholders is not counted in the calculation of the period of notice.
9.3 If all shareholders are present or represented at a general meeting of the shareholders and have waived the
convening notice requirements, the meeting may be held without prior notice.
9.4 Each shareholder is entitled to be accompanied or represented at a general meeting of the shareholders by another
shareholder authorised by a written power of attorney or by a lawyer, tax advisor or auditor under a professional duty
of confidentiality.
9.5 Unless a notarial record is made of the negotiations of the general meeting of the shareholders, a written record
must be made concerning the course of the meeting (for purposes of proof, not as a precondition of validity), which must
state the place and date of the meeting, the participants, the items on the agenda, the main content of the negotiations
and the shareholders’ resolutions. The written record must be signed by all shareholders present or represented at the
meeting of the shareholders (for purposes of proof, not as a precondition of validity). Each shareholder must be sent a
copy of the written record.
Art. 10. Quorum and vote.
10.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
10.2 A general meeting of the shareholders will only constitute a quorum if at least 80% of the share capital is repre-
sented and if all shareholders of the Company have been duly notified of such general meeting of the shareholders in
compliance with Article 9. Unless otherwise provided for by the Law or these articles of association, collective decisions
of the Company’s shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than
half of the share capital. If there is no quorum, a new general meeting of the shareholders with the same agenda must be
called without undue delay in compliance with Article 9.2. Such general meeting of the shareholders shall then constitute
a quorum regardless of the share capital represented, if this was pointed out in the notice calling such meeting and the
decisions shall be taken at the simple majority of the votes cast.
Art. 11. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.
Art. 12. Amendments of articles of association. Any amendment of these articles of association requires the approval
of (i) a majority in number of shareholders (ii) who are also a Super Majority.
D. Board of managers - Advisory board
Art. 13. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
13.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers
form a board of managers.
13.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not
expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of
association is to be construed as a reference to the “sole manager”.
162543
L
U X E M B O U R G
13.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name and on behalf of the Company and
to take any actions necessary or useful to fulfil the Company’s corporate purpose, with the exception of the powers
reserved by the Law or by these articles of association to the general meeting of the shareholders.
Art. 14. Election, removal and term of office of managers.
14.1 The manager(s) shall be elected and removed by the general meeting of the shareholders which shall determine
their remuneration and term of office.
14.2 The managers shall be elected and may be removed from office at any time, with or without cause.
14.3 The general meeting of the shareholders may decide to appoint managers of two (2) different classes, being class
A managers and class B managers, provided that there can only be up to two class A managers and two class B managers
at any time. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant shareholders’
resolutions and the managers be identified with respect to the class they belong.
Art. 15. Vacancy in the office of a manager.
15.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or
otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the replaced manager by the remaining managers until the next general meeting of the shareholders which shall resolve
on the permanent appointment, in compliance with the applicable legal provisions.
15.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company’s sole manager, such vacancy must be filled without undue
delay by the general meeting of the shareholders.
Art. 16. Convening meetings of the board of managers.
16.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held
at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.
16.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers at least twenty-four (24)
hours in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such document being
sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined
in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.
16.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive
any convening notice requirements or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the
board of managers.
Art. 17. Board of Managers.
17.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not
need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
17.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any
such meeting.
17.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either
in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.
17.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other
means of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis
and allowing an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a
participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.
17.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or
represented at a meeting of the board of managers.
17.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting, except as
otherwise provided by law, these articles of association or the rules of procedure for the board of managers. The chairman,
if any, shall not have a casting vote. In the event however the general meeting of the shareholders has appointed different
classes of managers (namely class A managers and class B managers), any resolutions of the board of managers may only
be validly taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which
may be represented), except as otherwise provided by law, these articles of association or the rules of procedure for the
board of managers.
17.7 The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in
writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be
the date of the last signature.
17.8 The shareholders have adopted and issued rules of procedure for the board of managers.
162544
L
U X E M B O U R G
17.9 The managers shall require the written consent of the Advisory board (as defined in 20.1 below) which may be
granted via facsimile or e-mail or in any other written way, for legal transactions and measures which are specified from
time to time in the rules of procedure for the Board of Managers adopted pursuant to 17.8 above. No consent is required
if such legal transactions and measures have in advance been specifically listed in and approved by an adopted budget with
the unanimous consent of the shareholders.
17.10 The general meeting of the shareholders or the Advisory Board may by unanimous resolution amend the rules
of procedure for the board of managers at any time (e.g. determining further transactions and measures requiring the
consent of the Advisory board). The Advisory Board may give its consent also in advance for certain groups and kinds of
transactions and measures.
17.11 Any amendments to the rules of procedure for the board of managers adopted in accordance with Article 17.10
will be effective as from their notification to the board of managers. Such amendments will be acknowledged, and to the
extent necessary approved by the board of managers at the occasion of its next meeting.
Art. 18. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
18.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by
the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. In the event the general meeting of
the shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) under the
joint signature of one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation). Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman,
if any, or by any two (2) managers. In the event the general meeting of the shareholders has appointed different classes
of managers (namely class A managers and class B managers) under the joint signature of one (1) class A manager and
one (1) class B manager (including by way of representation).
18.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.
Art. 19. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the
signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers;
in the event the general meeting of the shareholders has appointed different classes of managers (namely class A manager
and class B manager), the Company will only be validly bound by the joint signature of at least one (1) class A manager
and one (1) class B manager (including by way of representation) or (ii) by the joint signature or the sole signature of any
person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers, within the limits of such
delegation.
Art. 20. Advisory Board.
20.1 The Company shall have an advisory board (the “Advisory Board”). It shall be composed according to the rules
set out in 20.2 and 20.3 below.
20.2 The general meeting of the shareholders of the Company shall appoint the members of the Advisory Board.
20.3 The general meeting of the shareholders may by way of a unanimous shareholders’ resolution increase or decrease
the number of members of the Advisory Board. Each of the shareholders may nominate one or several non-voting member
(s) of the Advisory Board.
20.4 The general meeting of the shareholders shall only amend the adopted rules of procedure for the Advisory Board
by way of a unanimous shareholders’ resolution.
20.5 Any amendments to the rules of procedure for the Advisory Board adopted in accordance with Article 20.4 will
be effective as from their notification to the Advisory Board. Such amendments will be acknowledged, and to the extent
necessary approved by the Advisory Board at the occasion of its next meeting.
20.6 The Advisory Board shall have a chairman and a vice-chairman. The rules of procedure for the Advisory Board
shall provide for further provisions in particular on the self-organisation of the Advisory Board.
20.7 The Advisory Board shall be competent for the granting of consents to any transactions and measures of the
managers which require the consent of the Advisory Board pursuant to (i) the rules of procedure for the Advisory Board,
(ii) the rules of procedure for the board of managers, (iii) respective shareholders´ resolutions or (iv) in these Articles.
E. Audit and supervision
Art. 21. Auditor(s).
21.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company
shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of the shareholders shall
appoint the internal auditor(s) and shall determine their term of office.
21.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting
of the shareholders.
21.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
162545
L
U X E M B O U R G
21.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d’entreprises agréé
(s)) in accordance with article 69. of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies’ register and the
accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.
21.5 An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its
approval.
F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends
Art. 22. Financial Year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end
on the thirty-first of December of the same year.
Art. 23. Annual Accounts and Allocation of Profits.
23.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of
the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.
23.2 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve.
This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten
per cent (10%) of the share capital of the Company.
23.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the
contributing shareholder agrees with such allocation.
23.4 In case of a share capital reduction, the Company’s legal reserve may be reduced in proportion so that it does
not exceed ten per cent (10%) of the share capital.
23.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the
remainder of the Company’s annual net profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.
23.6 Dividend distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the
Company and as set out in any shareholders’ agreement which may exist between them.
23.7 In addition to those rights to which they are entitled by application of law, the shareholders shall have such rights
of information as set out in any shareholders’ agreement which may exist between them.
Art. 24. Interim dividends - Share Premium and Assimilated Premiums.
24.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared
by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed shall
be allocated where applicable and may not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by
profits carried forward and distributable reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to
a reserve which the Law or these articles of association do not allow to be distributed.
24.2 Any interim dividends distributed by the board of managers in accordance with article 24.1 will need to be
confirmed by the ordinary general meeting of the shareholders on the basis of the annual accounts of the relevant financial
year.
24.3 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the share-
holders subject to the provisions of the Law and these articles of association.
G. Liquidation
Art. 25. Liquidation.
25.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with Article 3.2 of these articles of association, the
liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of the shareholders
deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided,
the liquidators shall have the most extensive powers for the realization of the assets and payment of the liabilities of the
Company.
25.2 The liquidation proceeds shall be allocated in accordance with the applicable provisions of any shareholders’
agreement entered into by and between the shareholders from time to time.
H. Final clauses
Art. 26. Governing law.
26.1 All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the Law and any
shareholders’ agreement which may be entered into from time to time between the shareholders and the Company, and
which may supplement certain provisions of these articles.
26.2 These articles are worded in English followed by a German translation; in case of divergence between the English
and the German text, the English version shall prevail.
Art. 27. Severability.
27.1 In addition, the general legal requirements for companies shall apply.
162546
L
U X E M B O U R G
27.2 These articles of association continue to be valid even if a provision hereof turns out to be invalid. The invalid
provision shall be supplemented or reinterpreted such that the economic purpose intended by the invalid provision will
be achieved. The same applies if it turns out during the implementation of the articles of association that they contain a
gap that needs to be filled.”
5. Miscellaneous.
Having duly considered each item of the agenda, the general meeting of shareholders unanimously takes the following
resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting of shareholders accepts Al Wokaer Holding S.P.C., aforementioned, as new shareholder of the
Company.
<i>Second resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves to increase the share capital of the Company by an amount of twenty-
five thousand euro (EUR 25,000) so as to raise it from its current amount of twenty-five thousand euro (EUR 25,000) up
to fifty thousand euro (EUR 50,000) by issuing twenty-five thousand (25,000) shares with a nominal value of one euro
(EUR 1.00) each.
<i>Subscriptioni>
The twenty-five thousand shares (25,000) shares have been duly subscribed by AI Wokaer, aforementioned, here
represented as aformentioned, for the price of twenty-five thousand euro (EUR 25,000).
<i>Paymenti>
The twenty-five thousand shares (25,000) shares subscribed by AI Wokaer, aforementioned, have been entirely paid
up through a contribution in cash in an amount of twenty-five thousand euro (EUR 25,000).
The amount of twenty-five thousand euro (EUR 25,000) is as now available to the Company as has been proved to
the undersigned notary.
The contribution in the amount of twenty-five thousand euro (EUR 25,000) is entirely allocated to the share capital.
<i>Third resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves the amendment of article five (5) of the articles of association of the
Company so that it shall now henceforth read as follows:
« Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company’s share capital is set at fifty thousand Euros (EUR 50,000.00) represented by fifty thousand (50,000)
shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each.
The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by these
articles of association or by the Law.
5.2 The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.”
<i>Fourth resolutioni>
Inter alia as a result of the foregoing, the general meeting of shareholders unanimously resolves to fully restate the
articles of association of the Company which shall henceforth read as set out in the agenda of the present deed.
<i>Costs and expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are
estimated at approximately EUR 2,000.-.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-
ment.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,
the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing parties
and in case of divergence between the English and the German text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name
and residence, the said proxyholder signed together with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:
Im Jahre zweitausendvierzehn, am achtundzwanzigsten August.
vor uns, dem unterzeichnenden Notar Maître Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxem-
burg,
162547
L
U X E M B O U R G
SIND ERSCHIENEN:
1. Rocket Internet AG (vormals Rocket Internet GmbH), eine Aktiengesellschaft bestehend unter deutschem Recht,
mit satzungsmäßigem Sitz in Berlin, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg,
Deutschland, unter der Nummer HRB 159634 B, mit Geschäftssitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Deutschland,
(„Rocket“),
Inhaber von fünfundzwanzigtausend (25.000) Anteilen der Gesellschaft,
hier vertreten durch Herr Philippe Sylvestre, Maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht
ausgestellt in Berlin, Deutschland, am 31. Juli 2014;
2. Al Wokaer Holding S.P.C., eine single person company (Ein-Personen-Gesellschaft) gegründet nach dem Recht des
Königreichs Bahrain, eingetragen beim Ministry of Industry & Commerce of the Kingdom of Bahrain unter der Eintra-
gungsnummer 87226-1 („Al Wokaer“), ausschließlich für die Punkte 3 ff. der Tagesordnung teilnahme- und stimmbe-
rechtigt,
zukünftiger Inhaber von fünfundzwanzigtausend (25.000) Anteilen der Gesellschaft,
hier vertreten durch Herr Philippe Sylvestre, Maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht
vom 27. August 2014, ausgestellt in Singapur.
Besagte Vollmachten, welche von der Bevollmächtigten der erschienenen Parteien und dem Notar ne varietur para-
phiert wurden, werden der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.
Rocket ist der alleinige Gesellschafter der Asia Internet Holding S.à r.l., einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung
(société à responsabilité limitée), gegründet und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz
in 7, avenue Pescatore, L-2324 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der
Nummer B 177.038, gegründet am 19. April 2013 gemäß einer Urkunde des unterzeichnenden Notars, welche am 26.
Juni 2013 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1518 veröffentlicht wurde. Die Satzung der
Gesellschaft wurde zuletzt am 4. April 2014 gemäß einer Urkunde des Notars Maître Marc Loesch, mit Amtssitz in
Mondorf-les-Bains, geändert, welche am 5. Juli 2014 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1747,
veröffentlicht wurde.
Da Rocket das gesamte Gesellschaftskapital vertritt und auf jegliche Ladungsformalitäten verzichtet hat, ist die Ge-
sellschafterversammlung ordnungsgemäß zusammengekommen und kann wirksam über die folgende Tagesordnung
verhandeln, wobei AI Wokaer ausschließlich für die Punkte 3 ff. der Tagesordnung teilnahme- und stimmberechtigt ist:
<i>Tagesordnungi>
1. Aufnahme von Al Wokaer Holding S.P.C., einer single person company (Ein-Personen-Gesellschaft) gegründet nach
dem Recht des Königreichs Bahrain, eingetragen beim Ministry of Industry & Commerce of the Kingdom of Bahrain unter
der Eintragungsnummer 87226-1, als neuer Gesellschafter der Gesellschaft.
2. Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von fünfundzwanzigtausend Euro
(EUR 25.000) um einen Betrag von fünfundzwanzigtausend Euro (EUR 25.000) auf einen Betrag von fünfzigtausend Euro
(EUR 50.000) durch die Ausgabe von fünfundzwanzigtausend (25.000) Anteilen mit einem Nominalwert von je einem
Euro (EUR 1).
3. Dementsprechende Änderung des Artikels fünf (5) der Satzung der Gesellschaft, welcher nunmehr wie folgt lautet:
„ Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt fünfzigtausend Euro (EUR 50.000,00), bestehend aus fünfzigtau-
send (50.000) Anteilen mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1).
Die mit den Anteilen verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es wird in dieser Satzung oder
durch das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.
5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-
zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.“
4. Gänzliche Neufassung der Satzung der Gesellschaft, welche nunmehr wie folgt lautet:
„A. Name - Zweck - Dauer - Sitz
Art. 1. Name. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen
Asia Internet Holding S.à r.l. (die „Gesellschaft”), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über
Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Ge-
sellschaften, sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung
oder auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung,
Kontrolle und Entwicklung ihrer Beteiligungen.
162548
L
U X E M B O U R G
2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder
Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören Garantien geben,
Sicherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.
2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere
durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren oder
Schuldtiteln, Schuldverschreibungen und Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheinen bzw. Wertpapie-
ren.
2.4 Der Zweck der Gesellschaft ist auch (i) der Erwerb durch Kauf, Eintragung oder in jeder anderen Form, sowie die
Übertragung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Art von geistigem Eigentum und gewerblichen Schutzrechten, (ii)
die Erteilung von Lizenzen bezüglich solchem geistigen Eigentum und solcher gewerblicher Schutzrechte, und (iii) das
Innehaben und die Verwaltung von geistigem Eigentum und gewerblichen Schutzrechten.
2.5 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur, sowie
solche, welche geistiges Eigentum oder Grundeigentum betreffen, vornehmen, die ihr zur Erreichung dieser Zwecke
förderlich erscheinen, im Hinblick auf deren Verwertung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Art.
Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden,
welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird.
Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in der Stadt Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Rates der Geschäftsführer
verlegt werden. Durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Satzungsänderung erfor-
derlichen Art und Weise gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.
4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer im
Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.
4.4 Sollte der Rat der Geschäftsführer entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale
Entwicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an
ihrem Gesellschaftssitz beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz bis zur endgültigen Beendigung dieser
außergewöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben
keine Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes
eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.
B. Gesellschaftskapital - Anteile
Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt fünfzigtausend Euro (EUR 50.000,00), bestehend aus fünfzigtau-
send (50.000) Anteilen mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1).
Die mit den Anteilen verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es wird in dieser Satzung oder
durch das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.
5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-
zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.
Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit jeweils dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht über-
schreiten darf.
6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, die Insolvenz oder ein ver-
gleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.
6.5 Die Gesellschaft kann Einlagen ohne Ausgabe von Anteilen oder anderen Sicherheiten als Gegenleistung annehmen
und diese einer oder mehreren ausschüttbaren Rücklagen zuführen. Entscheidungen bezüglich der Verwendung solcher
ausschüttbarer Rücklagen werden gegebenenfalls von dem(den) Gesellschafter(n) oder Geschäftsführer(n) unter Berück-
sichtigung des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung getroffen.
Art. 7. Anteilsregister - Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden
kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.
7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten
wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft
162549
L
U X E M B O U R G
ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.
7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.
7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der einstimmigen Zustimmung aller Gesell-
schafter übertragen werden, außer bei Übertragungen, die als solche in Gesellschaftervereinbarungen, welche mitunter
zwischen den Gesellschaftern eingegangen werden, sofern vorhanden, bezeichnet wurden, insbesondere Vorkaufsrechte,
Bezugsrechte oder Mitverkaufsrechte-oder Pflichten aus Gesellschaftervereinbarungen, welche mitunter zwischen den
Gesellschaftern eingegangen werden, wobei die Zustimmung einer Qualifizierten Mehrheit (wie unten definiert) selbst-
verständlich immer erforderlich ist.
7.5 Artikel 7.4 gilt entsprechend für den Abschluss von Treuhandverhältnissen, Pfandverträgen, die Erteilung von Un-
terbeteiligungen, die Abtretung von und Aufrechnung mit Ansprüchen und Rechten, die sich aus Gesellschaftsanteilen
ergeben und insbesondere mit Ansprüchen auf Gewinnauszahlung, mit Ausnahme des Abschlusses von Pfandverträgen
mit und der Abtretung von Ansprüchen an Banken in Verbindung mit externen Finanzierungsverträgen; diese unterliegen
dem Abstimmungsabkommen gemäß Artikel 7.4.
7.6 Eine Übertragung, Abtretung oder andere Veräußerung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten
gemäß Artikel 1690 des Code Civil wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung, Abtretung oder anderen
Veräußerung in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung, Abtretung oder anderen Veräußerung zugestimmt hat.
7.7 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters nur an neue Gesellschafter übertragen werden,
wenn eine Mehrheit der Gesellschafter, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals halten (eine „Qualifizierte
Mehrheit“), einer solchen Übertragung zustimmt (wobei die Anteile des verstorbenen Gesellschafters für diese Zwecke
nicht berücksichtigt werden). Eine derartige Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn die Anteile an Eltern, Nachkommen
oder den/die überlebende/n Ehepartner/in oder jeden anderen gesetzlichen Erben des verstorbenen Gesellschafters
übertragen werden.
C. Entscheidungen der Gesellschafter
Art. 8. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
8.1 Die Gesellschafterversammlung ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch das anwendbare Recht und
diese Satzung ausdrücklich vorbehalten sind.
8.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.
8.3 Falls und solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, dürfen gemeinsame Ent-
scheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung vorbehalten wären, schriftlich gefasst werden. In diesem
Fall erhält jeder Gesellschafter den Text der zu fassenden Beschlüsse oder Entscheidungen in ausformulierter Form und
übt sein Stimmrecht schriftlich aus.
8.4 Gesellschafterbeschlüsse werden in Versammlungen gefasst. Sofern nicht zwingende gesetzliche Vorschriften eine
andere Form vorschreiben, können sie auch außerhalb von Versammlungen in schriftlicher Form (einschließlich E-Mail)
oder durch telefonische Abstimmung gefasst werden, sofern ein solches Verfahren von einem Gesellschafter ersucht wird
und kein anderer Gesellschafter innerhalb von zwei (2) Wochen in schriftlicher Form Widerspruch gegen dieses Verfahren
gegenüber dem Rat der Geschäftsführer der Gesellschaft einlegt. Wird innerhalb von zwei (2) Wochen kein Widerspruch
gemäß des vorstehenden Satzes eingelegt, so werden die Stimmen der nicht an der Abstimmung teilnehmenden Gesell-
schafter als Enthaltungen gewertet. Schriftliche Beschlüsse sind von jedem Gesellschafter zu unterzeichnen und die
Niederschrift ist jedem Gesellschafter unverzüglich zuzusenden. Beschlüsse, welche nicht in schriftlicher Form gefasst
werden, sind schriftlich zu bestätigen. Eine solche Bestätigung hat ausschließlich feststellende Bedeutung.
8.5 Von jedem Beschluss, der in Gesellschafterversammlungen gefasst wurde, ist unverzüglich eine Niederschrift an-
zufertigen (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die Wirksamkeit), die das Datum und die Form des gefassten
Beschlusses, den Inhalt des Beschlusses und die abgegebenen Stimmen zu enthalten hat, es sei denn, die Gesellschafter-
beschlüsse wurden notariell beurkundet. Die Niederschrift muss jedem Gesellschafter unverzüglich in schriftlicher Form
zugesendet werden.
8.6 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschriften
des Abschnitts XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jede Bezugnahme auf die „Gesell-
schafterversammlung“ in der vorliegenden Satzung als Bezugnahme auf den Alleingesellschafter, je nach Zusammenhang
und soweit anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingesellschafter
ausgeübt.
Art. 9. Gesellschafterversammlung.
9.1 Gesellschafterversammlungen finden am Sitz der Gesellschaft oder an einem Ort und zu einer Zeit statt, welche
in der entsprechenden Einladung genauer bestimmt werden.
9.2 Die Gesellschafterversammlung wird mittels Einschreiben (Zustellung zu eigenen Händen, Einschreiben oder Ein-
schreiben mit Rückschein) an jeden Gesellschafter einberufen und beinhaltet den Ort, das Datum, die Uhrzeit und die
Tagesordnung, wobei bei ordentlichen Gesellschafterversammlungen eine Ankündigungsfrist von mindestens vier (4)
Wochen und bei außerordentlichen Gesellschafterversammlungen eine Ankündigungsfrist von mindestens zwei (2) Wo-
162550
L
U X E M B O U R G
chen einzuhalten ist. Die Ankündigungsfrist beginnt am Tag nach dem Versand. Der Tag der Gesellschafterversammlung
wird bei der Berechnung der Ankündigungsfrist nicht berücksichtigt.
9.3 Falls alle Gesellschafter in einer Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten sind und auf Einladungsvo-
raussetzungen verzichtet haben, kann die Versammlung auch ohne vorherige Ankündigung abgehalten werden.
9.4 Jeder Gesellschafter ist dazu berechtigt, bei einer Gesellschafterversammlung von einem anderen durch eine
schriftliche Vollmacht dazu berechtigten Gesellschafter oder von einem Anwalt, Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer
unter der Berufsverschwiegenheitspflicht begleitet oder vertreten zu werden.
9.5 Eine Niederschrift hinsichtlich des Ablaufs der Versammlung ist (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die
Wirksamkeit) anzufertigen und hat den Ort und das Datum der Versammlung, die Teilnehmer, die Tagesordnungspunkte,
den Hauptinhalt der Verhandlungen und die Gesellschafterbeschlüsse zu beinhalten, es sei denn, die Verhandlungen der
Gesellschafterversammlung wurden notariell beurkundet. Die Niederschrift ist von allen bei der Gesellschafterversamm-
lung anwesenden oder vertretenen Gesellschaftern zu unterzeichnen (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die
Wirksamkeit). Jedem Gesellschafter ist eine Kopie der Niederschrift zuzusenden.
Art. 10. Quorum und Abstimmung.
10.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.
10.2 Eine Gesellschafterversammlung ist nur dann beschlussfähig, wenn mindestens 80% des Gesellschaftskapitals ver-
treten sind und wenn alle Gesellschafter der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 9 ordnungsgemäß über die Einberufung
der Gesellschafterversammlung unterrichtet wurden. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter sind nur mit der
Zustimmung von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals innehaben, gültig gefasst, es sei denn,
es wird durch das Gesetz von 1915 oder in dieser Satzung etwas Gegenteiliges bestimmt. Bei Beschlussunfähigkeit ist
unverzüglich im Einklang mit Artikel 9.2 eine neue Gesellschafterversammlung mit derselben Tagesordnung einzuberufen.
Diese Gesellschafterversammlung ist dann unabhängig von dem vertretenen Gesellschaftskapital beschlussfähig, sofern
darauf in der die Versammlung einberufenden Ladung hingewiesen wurde und Beschlüsse werden mit der einfachen
Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.
Art. 11. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.
Art. 12. Änderung der Satzung. Eine Änderung dieser Satzung erfordert die Zustimmung (i) einer zahlenmäßigen
Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die gleichzeitig eine Qualifizierte Mehrheit darstellen.
D. Rat der Geschäftsführer - Beirat
Art. 13. Befugnisse des alleinigen Geschäftsführers - Zusammensetzung und Befugnisse des Rates der Geschäftsführer.
13.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Ge-
schäftsführer hat, bilden diese einen Rat der Geschäftsführer.
13.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „alleiniger Ge-
schäftsführer“ nicht ausdrücklich in dieser Satzung verwendet wird, ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Rat der
Geschäftsführer“ als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer“ auszulegen.
13.3 Der Rat der Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, im Namen und auf Rechnung der
Gesellschaft zu handeln und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder
nützlich sind, mit Ausnahme der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung
vorbehaltenen Befugnisse.
Art. 14. Ernennung, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
14.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung ernannt und abberufen, welche ihre
Bezüge und ihre Amtszeit festlegt.
14.2 Die Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund ernannt oder abberufen werden.
14.3 Die Gesellschafterversammlung kann die Ernennung von Geschäftsführern zwei (2) unterschiedlicher Kategorien
beschließen, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B, mit der Maßgabe, dass es
jederzeit höchstens zwei Geschäftsführer der Kategorie A und zwei Geschäftsführer der Kategorie B geben kann. Eine
solche Klassifizierung der Geschäftsführer muss ordnungsgemäß in der Niederschrift der betreffenden Gesellschafterbe-
schlüsse festgehalten und die Geschäftsführer der Kategorie, der sie angehören, zugeordnet werden.
Art. 15. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
15.1 Scheidet ein Geschäftsführer durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Insolvenz, Rücktritt oder aus einem anderem
Grund aus seinem Amt aus, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen
die ursprüngliche Amtszeit des ersetzten Geschäftsführers nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesell-
schafterversammlung ausgefüllt werden, welche im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die
endgültige Ernennung entscheidet.
15.2 Für den Fall, dass der alleinige Geschäftsführer der Gesellschaft aus seinem Amt ausscheidet, muss die frei ge-
wordene Stelle unverzüglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.
162551
L
U X E M B O U R G
Art. 16. Einladung zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
16.1 Der Rat der Geschäftsführer versammelt sich auf Einberufung durch einen Geschäftsführer. Die Sitzungen des
Rates der Geschäftsführer finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.
16.2 Die Geschäftsführer werden mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung anberaumten
Zeitpunkt zu jeder Sitzung des Rates der Geschäftsführer schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe
der Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Geschäftsführer
per Post, Fax, E-Mail oder mittels eines anderen vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abgegeben
haben, wobei eine Kopie eines solchen Dokuments ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung zu Sitzungen des Rates
der Geschäftsführer ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss des Rates der Ge-
schäftsführer bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.
16.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle
Einladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Rates
der Geschäftsführer diesen zustimmen und diese unterzeichnen.
Art. 17. Rat der Geschäftsführer.
17.1 Der Rat der Geschäftsführer kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Rat der Ge-
schäftsführer kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise selbst ein Geschäftsführer sein muss
und der für die Protokollführung der Sitzungen des Rates der Geschäftsführer verantwortlich ist.
17.2 Sitzungen des Rates der Geschäftsführer werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Rates der Ge-
schäftsführer geleitet. In dessen Abwesenheit kann der Rat der Geschäftsführer einen anderen Geschäftsführer durch
einen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Mitglieder als Vorsitzenden pro tempore ernennen.
17.3 Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer teilnehmen, indem er einen anderen
Geschäftsführer schriftlich oder durch Faxschreiben, per E-Mail oder durch ein anderes vergleichbares Kommunikati-
onsmittel bevollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Geschäftsführer
kann einen oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.
17.4 Eine Sitzung des Rates der Geschäftsführer kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein
anderes Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu
hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel
ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung gilt als am Sitz der Ge-
sellschaft abgehalten.
17.5 Der Rat der Geschäftsführer kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest eine Mehrheit der
Geschäftsführer in einer Sitzung anwesend oder vertreten ist.
17.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Rates der Geschäftsführer
teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst, es sei denn, es wird durch das Gesetz, in dieser Satzung oder
in der Geschäftsordnung für den Rat der Geschäftsführer etwas Gegenteiliges bestimmt. Der Vorsitzende des Rates der
Geschäftsführer, falls vorhanden, hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme. Sofern die Gesell-
schafterversammlung allerdings unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer
der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B), werden Beschlüsse des Rates der Geschäftsführer nur dann
wirksam gefasst, wenn sie von der Mehrheit der Geschäftsführer einschließlich mindestens eines Geschäftsführers der
Kategorie A und eines Geschäftsführers der Kategorie B (oder deren Vertreter) gefasst werden, es sei denn, es wird
durch das Gesetz, in dieser Satzung oder in der Geschäftsordnung für den Rat der Geschäftsführer etwas Gegenteiliges
bestimmt.
17.7 Der Rat der Geschäftsführer kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung,
per Faxschreiben, E-Mail oder durch ein anderes vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Jeder Geschäftsführer kann
seine Zustimmung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreff-
enden Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.
17.8 Die Gesellschafter haben eine Geschäftsordnung für den Rat der Geschäftsführer beschlossen und bekanntgege-
ben.
17.9 Die Geschäftsführer benötigen die schriftliche Zustimmung des Beirats (wie in Artikel 20.1 definiert), welche per
Fax oder E-Mail oder in jeder anderen schriftlichen Form erteilt werden kann, für Rechtsgeschäfte und Maßnahmen,
welche in der gemäß Artikel 17.8 beschlossenen Geschäftsordnung für den Rat der Geschäftsführer mitunter festgelegt
werden. Eine Zustimmung ist nicht erforderlich, sofern solche Rechtsgeschäfte und Maßnahmen im Voraus in einem
bewilligten Haushaltsplan ausdrücklich aufgeführt und mit der einstimmigen Zustimmung der Gesellschafter genehmigt
wurden.
17.10 Die Gesellschafterversammlung oder der Beirat kann die Geschäftsordnung für den Rat der Geschäftsführer
jederzeit durch einstimmigen Beschluss ändern (z.B. durch die Festlegung weiterer Transaktionen und Maßnahmen, die
der Zustimmung des Beirats bedürfen). Der Beirat kann seine Zustimmung für bestimmte Gruppen und Arten von
Transaktionen und Maßnahmen auch im Voraus erteilen.
17.11 Änderungen an der Geschäftsordnung für den Rat der Geschäftsführer, welche im Einklang mit Artikel 17.10
beschlossen wurden, sind wirksam, sobald der Rat der Geschäftsführer darüber in Kenntnis gesetzt wurde. Diese Ände-
162552
L
U X E M B O U R G
rungen werden im Rahmen der nächsten Sitzung des Rates der Geschäftsführer von diesem zur Kenntnis genommen und,
soweit erforderlich, angenommen.
Art. 18. Protokoll von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer; Protokoll der Entscheidungen des alleinigen Ge-
schäftsführers.
18.1 Das Protokoll einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer wird vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer,
falls vorhanden oder, im Falle seiner Abwesenheit, vom Vorsitzenden pro tempore und dem Schriftführer (falls vorhan-
den), oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unterschied-
liche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der
Kategorie B), werden Protokolle von einem (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einem (1) Geschäftsführer der
Kategorie B (oder deren Vertreter) gemeinsam unterzeichnet. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem
Gerichtsverfahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Rates der Ge-
schäftsführer, falls vorhanden, oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafter-
versammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A
und Geschäftsführer der Kategorie B), werden solche Kopien oder Auszüge von einem (1) Geschäftsführer der Kategorie
A und einem (1) Geschäftsführer der Kategorie B (oder deren Vertreter) gemeinsam unterzeichnet.
18.2 Die Entscheidungen des alleinigen Geschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom alleinigen
Geschäftsführer unterzeichnet wird. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet.
Art. 19. Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Um-
ständen (i) durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder, für den Fall, dass die Gesellschaft mehrere
Geschäftsführer hat, durch die gemeinsame Unterschrift zwei (2) beliebiger Geschäftsführer wirksam verpflichtet; sofern
die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer
der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B), wird die Gesellschaft nur durch die gemeinsame Unterschrift
mindestens eines (1) Geschäftsführers der Kategorie A und eines (1) Geschäftsführers der Kategorie B (oder deren
Vertreter), oder (ii) durch die gemeinsame Unterschrift oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/denen
eine Unterschriftsbefugnis durch den Rat der Geschäftsführer übertragen worden ist, wirksam verpflichtet.
Art. 20. Beirat.
20.1 Die Gesellschaft hat einen Beirat (der „Beirat“). Dieser ist im Einklang mit den in Artikel 20.2 und 20.3 festgelegten
Regeln zusammenzusetzen.
20.2 Die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft ernennt die Mitglieder des Beirats.
20.3 Die Gesellschafterversammlung kann durch einen einstimmigen Gesellschafterbeschluss die Anzahl der Mitglieder
des Beirats erhöhen oder herabsetzen. Jeder der Gesellschafter kann ein oder mehrere nichtstimmberechtigte(s) Mitglied
(er) des Beirats ernennen.
20.4 Die Gesellschafterversammlung kann die beschlossene Geschäftsordnung für den Beirat nur durch einen ein-
stimmigen Gesellschafterbeschluss ändern.
20.5 Änderungen an der Geschäftsordnung für den Beirat, welche im Einklang mit Artikel 20.4 beschlossen wurden,
sind wirksam, sobald der Beirat darüber in Kenntnis gesetzt wurde. Diese Änderungen werden im Rahmen der nächsten
Sitzung des Beirats von diesem zur Kenntnis genommen und, soweit erforderlich, angenommen.
20.6 Der Beirat hat einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden. Die Geschäftsordnung für den Beirat
hat weitere Bestimmungen, insbesondere hinsichtlich der Selbstorganisation des Beirats, zu enthalten.
20.7 Der Beirat ist für die Erteilung von Zustimmungen zu Transkationen und Maßnahmen der Geschäftsführer zu-
ständig, welche gemäß (i) der Geschäftsordnung für den Beirat, (ii) der Geschäftsordnung für den Rat der Geschäftsführer,
(iii) entsprechender Gesellschafterbeschlüsse oder (iv) dieser Satzung der Zustimmung des Beirats bedürfen.
E. Aufsicht und Prüfung der Gesellschaft
Art. 21. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
21.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der
Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)). Die Gesellschafterversammlung
ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.
21.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
21.3 Die Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Recht der permanenten Überprüfung und Kontrolle aller Ge-
schäfte der Gesellschaft.
21.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember
2002 betreffend das Handelsregister und die Buchhaltung und den Jahresabschluss von Unternehmen, in der jeweils
gültigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d’entreprises agréé(s)) ernennen, entfällt
die Funktion des Rechnungsprüfers.
21.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die
Gesellschafterversammlung abberufen werden.
162553
L
U X E M B O U R G
F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss -Gewinnverwendung - Abschlagsdividenden
Art. 22. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am
einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.
Art. 23. Jahresabschluss und Gewinne.
23.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Rat der Geschäftsführer erstellt im
Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und
Verlustrechnung.
23.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage
der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.
23.3 Durch einen Gesellschafter erbrachte Einlagen in Rücklagen können mit Zustimmung dieses Gesellschafters
ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.
23.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage der Gesellschaft verhältnis-
mäßig herabgesetzt werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.
23.5 Auf Vorschlag des Rates der Geschäftsführer bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den Be-
stimmungen des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung, wie der verbleibende jährliche Nettogewinn der Gesellschaft
verwendet werden soll.
23.6 Dividendenausschüttungen an die Gesellschafter erfolgen proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesell-
schaft gehaltenen Anteile und im Einklang mit möglichen Gesellschaftervereinbarungen zwischen den Gesellschaftern.
23.7 Neben den Rechten, die ihnen kraft Gesetzes zustehen, haben die Gesellschafter ein Recht auf Informationen,
welche ihnen im Einklang mit möglichen Gesellschaftervereinbarungen zwischen den Gesellschaftern zustehen.
Art. 24. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
24.1 Der Rat der Geschäftsführer kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche
vom Rat der Geschäftsführer vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur
Verfügung stehen. Der ausschüttbare Betrag wird gegebenenfalls verteilt und darf nicht die Summe der seit dem Ende
des vergangenen Geschäftsjahres angefallenen Gewinne, gegebenenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne und aus-
schüttbare Rücklagen, beziehungsweise vermindert durch vorgetragene Verluste und Summen, die einer Rücklage
zugeführt werden, welche nach dem Gesetz von 1915 oder dieser Satzung nicht ausgeschüttet werden darf, übersteigen.
24.2 Abschlagsdividenden, die vom Rat der Geschäftsführer im Einklang mit Artikel 24.1 ausgeschüttet werden, be-
dürfen der Bestätigung der ordentlichen Gesellschafterversammlung auf der Grundlage des Jahresabschlusses des
entsprechenden Geschäftsjahres.
24.3 Das Agio, andere Kapitalreserven oder andere ausschüttbare Rücklagen können im Einklang mit den Bestimmun-
gen des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.
G. Liquidation
Art. 25. Liquidation.
25.1 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Liquidation durch einen
oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, die über die Auflö-
sung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit nichts anderes
bestimmt wird, haben die Liquidatoren die weitestgehenden Befugnisse für die Verwertung der Vermögenswerte und die
Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
25.2 Die Liquidationserlöse werden im Einklang mit den anwendbaren Bestimmungen von Gesellschaftervereinbarun-
gen, die zwischen den Gesellschaftern mitunter eingegangen werden, verteilt.
H. Schlussbestimmungen
Art. 26. Anwendbares Recht.
26.1 Sämtliche in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten unterliegen den Bestimmungen des Gesetzes von
1915 und jeder Gesellschaftervereinbarung, die die Gesellschafter mit der Gesellschaft mitunter eingehen und durch die
bestimmte Bestimmungen dieser Satzung ergänzt werden könnten.
26.2 Diese Satzung wurde auf Englisch verfasst, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; im Falle von Abweichungen
zwischen der englischen und der deutschen Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.
Art. 27. Salvatorische Klausel.
27.1 Darüber hinaus gelten die allgemeinen gesetzlichen Vorschriften für Gesellschaften.
27.2 Diese Satzung bleibt auch dann wirksam, wenn sich eine ihrer Bestimmungen als unwirksam erweist. Die un-
wirksame Bestimmung wird ergänzt oder uminterpretiert, so dass dem wirtschaftlichen Zweck der ungültigen Bestimmung
entsprochen wird. Dies gilt auch, wenn sich während der Anwendung der Satzung herausstellen sollte, dass diese eine
auszufüllende Regelungslücke enthält.“
162554
L
U X E M B O U R G
5.Verschiedenes.
Nach ordnungsgemäßer Prüfung jedes Tagesordnungspunkts fasst die Gesellschafterversammlung einstimmig die fol-
genden Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung nimmt Al Wokaer Holding S.P.C., vorbenannt, als neuen Gesellschafter der Gesell-
schaft an.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt, das Gesellschaftskapital der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von
fünfundzwanzigtausend Euro (EUR 25.000) um einen Betrag von fünfundzwanzigtausend Euro (EUR 25.000) auf einen
Betrag von fünfzigtausend Euro (EUR 50.000) durch die Ausgabe von fünfundzwanzigtausend (25.000) Anteilen mit einem
Nominalwert von je einem Euro (EUR 1), zu erhöhen.
<i>Zeichnungi>
Die fünfundzwanzigtausend (25.000) Anteile wurden ordnungsgemäß von Al Wokaer, vorbenannt, hier vertreten wie
vorerwähnt, zu einem Preis von fünfundzwanzigtausend Euro (EUR 25.000) gezeichnet.
<i>Zahlungi>
Die von Al Wokaer, vorbenannt, gezeichneten fünfundzwanzigtausend (25.000) Anteile wurden vollständig eingezahlt
durch eine Bareinlage in Höhe von fünfundzwanzigtausend Euro (EUR 25.000).
Die Summe von fünfundzwanzigtausend Euro (EUR 25.000) steht der Gesellschaft ab sofort zur freien Verfügung so
wie es dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde.
Die Einlage in Höhe von fünfundzwanzigtausend Euro (EUR 25.000) wird vollständig dem Gesellschaftskapital zugeführt.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt, Artikel fünf (5) der Satzung der Gesellschaft zu ändern, welcher nunmehr
wie folgt lautet:
„ Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt fünfzigtausend Euro (EUR 50.000,00), bestehend aus fünfzigtau-
send (50.000) Anteilen mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1).
Die mit den Anteilen verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es wird in dieser Satzung oder
durch das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.
5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-
zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.“
<i>Vierter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt, unter anderem infolge des Vorstehenden, einstimmig die gänzliche Neu-
fassung der Satzung der Gesellschaft, welche nunmehr wie in der Tagesordnung der vorliegenden Urkunde dargestellt
lautet.
<i>Kosten und Auslageni>
Die Kosten, Auslagen, Honorare und Gebühren jeglicher Art, die von der Gesellschaft zu tragen sind, werden auf
ungefähr EUR 2.000,- geschätzt.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen.
Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache beherrscht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende
Urkunde auf Verlangen der erschienenen Parteien auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung;
auf Verlangen besagter erschienener Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen
Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.
Die vorstehende Urkunde ist der Bevollmächtigten der erschienenen Parteien, welche dem Notar mit Namen, Vorn-
amen und Wohnsitz bekannt ist, verlesen und vom Notar gemeinsam mit dieser Bevollmächtigten unterzeichnet worden.
Gezeichnet: P. SYLVESTRE und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 septembre 2014. Relation: LAC/2014/41085. Reçu soixante-quinze euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): C. FRISING.
- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - Der Gesellschaft auf Begehr erteilt.
162555
L
U X E M B O U R G
Luxemburg, den 6. November 2014.
Référence de publication: 2014171688/857.
(140196867) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2014.
HSBC Securities Services (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 16, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 28.531.
In the year two thousand and fourteen, on the twenty-eighth day of October,
Before us Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg,
was held
an extraordinary general meeting of the shareholders of HSBC Securities Services (Luxembourg) S.A., a société ano-
nyme, duly incorporated and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at
16, Boulevard d’Avranches, L-1160 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under
number B 28.531, incorporated pursuant to a deed of Maître Reginald Neuman, notary residing at the time in Luxembourg,
Grand-Duchy of Luxembourg, on 19 July 1988, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, on 29
September 1988, number 255. The articles of association have been amended for the last time on 17 December 2013,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 3 March 2014, number 559 (the "Company").
The meeting was opened at 5.00 p.m. with Mr Michael Jonas, Avocat à la Cour, professionally residing in Luxembourg,
in the chair,
who appointed as secretary Mr Philippe Sylvestre, Avocat, professionally residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mr Philippe Harles, Avocat, professionally residing in Luxembourg, in the chair, who
appointed as secretary
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Approval of the transfer of the assets and the thereto attached liabilities of the Company to HSBC Bank Plc, acting
through its Luxembourg branch, in accordance with the transfer plan set out on 28 July 2014, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2116 of 11 August 2014;
2. Miscellaneous.
II. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their
shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the repre-
sented shareholders and the board of the meeting, will remain annexed to this deed to be filed at the same time with the
registration authorities.
III. That the proxies of the represented shareholders, initialed “ne varietur” by the appearing parties, will also remain
annexed to this deed.
IV. That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and the shareholders present
or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no
convening notices were necessary.
V. That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deli-
berate on all the items of the agenda.
The general meeting then, after having duly acknowledged the statements made by the chairman, requested the un-
dersigned notary to record the following resolution:
WHEREAS, the shareholders have been able to take knowledge of:
- the transfer plan set out on 28 July 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number
2116 of 11 August 2014 (the “Transfer Plan”), whereby the Company transfers all the assets and the thereto attached
liabilities of the Company but save for the excluded liabilities as set out in the Transfer Plan (the “Transferred Assets and
Liabilities”), to HSBC Bank Plc, a public limited company, duly incorporated and existing under the laws of United Kingdom,
having its registered office at 8, Canada Square, London, E14 5HQ, United Kingdom, registered with the Companies
House under number 00014259, acting through its Luxembourg branch, HSBC Bank Plc, Luxembourg Branch, established
at 16, Boulevard d’Avranches, L-1160, Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register
under number B 178.455 (the “Transferee”), (the “Transfer”);
- the annual accounts and the management reports for the three last financial years of the Company; and
- the annual accounts and the management reports for the three last financial years of the Transferee.
WHEREAS, in accordance with article 295 of the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as
amended (the “Law”), the abovementioned documents were at the shareholders’ disposal at the registered office of the
Company, at least one month before the date of the present general meeting.
162556
L
U X E M B O U R G
WHEREAS, all the shareholders have provided the Company and the Transferee with waiver letters, whereby each
of them expressly confirms that it has been sufficiently informed about the Transfer and expressly waives the requirement
of (i) the examination of the Transfer Plan and the written report on the Transfer Plan made by an independent expert,
in accordance with Article 296 (1) of the Law, (ii) the interim financial statements of the Company and of the Transferee
and (iii) the report of the management bodies of the Company and the Transferee explaining the Transfer Plan and setting
out its legal and economic grounds, in accordance with Article 296 (2) of the Law.
<i>Sole resolution:i>
The general meeting resolves that the Transfer will be effective (i) between the Company and the Transferee, (ii) from
an accounting and tax perspective and (iii) vis-à-vis third parties, as of the date of the publication of the minutes of the
present extraordinary general meeting in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, for both the Company
and the Transferee.
The general meeting resolves that the Transfer is subject to the provisions on de-mergers as set out in Articles 285
to 308, except for Article 303 of the Law, and that the Transferred Assets and Liabilities will be transferred ipso jure by
the Company to the Transferee, in accordance with Article 308 bis-2 of the Law and with the Transfer Plan.
THEREFORE, the general meeting resolves to approve the Transfer as set out in the Transfer Plan and to confirm that
the Transferred Assets and Liabilities shall be transferred to the Transferee for the consideration as determined in the
Transfer Plan..
There being no further business, the meeting is closed
Whereof this deed is drawn up in Luxembourg on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be prevailing.
The document having been read to the appearing persons, said persons appearing signed together with the notary this
deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L’an deux mille quatorze, le vingt-huitième jour du mois d’octobre,
Par devant nous Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg,
s’est tenue
une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de HSBC Securities Services (Luxembourg) S.A., une société
anonyme, dûment constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 16,
Boulevard d’Avranches, L-1160 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 28.531, constituée suivant acte notarié devant Maître Reginald Neuman, notaire résidant à ce moment
au Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 19 Juillet 1988, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, en date du 29 septembre 1988, numéro 255. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois le 17
décembre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 3 mars 2014, numéro 559 (la
«Société»).
L’assemblée a été ouverte à 17.00 heures, sous la présidence de Monsieur Michael Jonas, Avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à Luxembourg,
a désigné comme secrétaire Monsieur Philippe Sylvestre, Avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg,
L’assemblée a élu comme scrutateur Monsieur Philippe Harles, Avocat, résidant professionnellement à Luxembourg.
Le bureau de l’assemblée ayant ainsi été constitué, le président a déclaré et prié le notaire d’acter:
I. Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Approbation de la cession des actifs et des passifs y attachés de la Société à HSBC Bank Plc, agissant par sa succursale
luxembourgeoise, HSBC Bank Plc, Luxembourg Branch, conformément au projet de cession établi le 28 juillet 2014, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2116 en date du 11 août 2014;
2. Divers.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre des actions
qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, signée par les actionnaires, les mandataires
des actionnaires représentés et le bureau de l’assemblée, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux
formalités d’enregistrement.
III. Que les procurations des actionnaires représentés, paraphées ne varietur par les parties comparantes, resteront
également annexées au présent acte.
162557
L
U X E M B O U R G
IV. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, les actionnaires présents
ou représentés déclarant avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, il a pu être
fait abstraction des convocations d'usage.
V. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir pris compte des déclarations faites par le président, a demandé au notaire soussigné
d’acter la résolution suivante:
ATTENDU QUE, les actionnaires ont pu prendre connaissance:
- du projet de cession établi le 28 juillet 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
2116 en date du 11 août 2014 (le «Projet de Cession»), aux termes duquel la Société cède tous ses actifs et les passifs y
attachés à l’exception des passifs exclus tels que déterminés dans le Projet de Cession (les «Actifs et Passifs Transférés»)
à HSBC Bank Plc, une public limited company, dûment constituée et existante sous les lois du Royaume-Uni, ayant son
siège social au 8, Canada Square, London, E14 5HQ, Royaume-Uni, immatriculée au Companies House sous le numéro
00014259, agissant par sa succursale luxembourgeoise, HSBC Bank Plc, établie au 16, Boulevard d'Avranches, L-1160,
Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B178.455 (le
«Cessionnaire»), (la «Cession»);
- les comptes annuels et les rapports de gestion des trois derniers exercices de la Société; et
- les comptes annuels et les rapports de gestion des trois derniers exercices du Cessionnaire.
ATTENDU QUE, conformément à l’article 295 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), les documents susmentionnés ont été mis à disposition des actionnaires au
siège social de la Société au moins un mois avant la date de la présente assemblée.
ATTENDU QUE, tous les actionnaires ont transmis des lettres de renonciation à la Société et au Cessionnaire, aux
termes desquelles chacun d’entre eux confirme expressément avoir été suffisamment informé sur la Cession et renonce
expressément à l’exigence (i) de l’examen du Projet de Cession et du rapport établis par un expert indépendant, en vertu
de l’article 296 (1) de la Loi, (ii) d’un état comptable intermédiaire de la Société et du Cessionnaire et (iii) du rapport des
organes de gestion de la Société et du Cessionnaire expliquant le Projet de Cession et le justifiant du point de vue juridique
et économique, en vertu de l’article 296 (2) de la Loi.
<i>Résolution unique:i>
L’assemblée générale décide que la Cession sera effective (i) entre la Société et les Cessionnaire, (ii) d’un point de vue
comptable et fiscal et (iii) visà-vis des tiers, à compter du jour de la publication du procès-verbal de la présente assemblée
générale extraordinaire au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, et ce tant pour la Société que pour le
Cessionnaire.
L’assemblée générale décide que la Cession est soumise aux dispositions concernant les scissions telles qu’énoncées
aux articles 285 à 308, à l’exception de l’article 303 de la Loi et que les Actifs et Passifs Transférés seront transférés par
la Société de plein droit au Cessionnaire, conformément à l’article 308 bis-2 de la Loi et au Projet de Cession.
PAR CONSEQUENT, l’assemblée générale décide d’approuver la Cession telle que prévue dans le Projet de Cession
et de confirmer que les Actifs et Passifs Transférés seront cédés en contrepartie d’une considération telle que déterminée
dans le Projet de Cession.
N’ayant plus rien à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate, sur demande des comparants, que le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, lesdits comparants ont signé le présent acte avec le
notaire.
Signé: M. JONAS, P. SYLVESTRE, P. HARLES, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 3 novembre 2014. Relation: EAC/2014/14756. Reçu soixante-quinze Euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Monique HALSDORF.
Référence de publication: 2014172032/158.
(140197113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2014.
162558
L
U X E M B O U R G
World Investments Company, en abrégé WIC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 86.321.
Saturno S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 79.951.
L'an deux mil quatorze, le vingt-neuf octobre.
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) La société anonyme WORLD INVESTMENTS COMPANY, en abrégé WIC S.A., établie et ayant son siège social à
L-1724 Luxembourg, 49, Boulevard du Prince Henri, inscrite au Registre de Commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 86.321,
ici représentée par Monsieur Claude GEIBEN, maître en droit, demeurant professionnellement à L-2227 Luxembourg,
12, avenue de la Porte-Neuve, en vertu des résolutions de son conseil d'administration adoptées en date du 27 octobre
2014, et en vertu desquelles pouvoirs ont été conférés au mandataire préqualifié par la prédite société; et
2) La société anonyme SATURNO S.A., établie et ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 79.951,
ici représentée par Monsieur Georges HELLENBRAND, maître en droit, demeurant professionnellement à L-2227
Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve, en vertu des résolutions de son conseil d'administration adoptées en date
du 27 octobre 2014, et en vertu desquelles pouvoirs ont été conférés au mandataire préqualifié par la prédite société.
Des copies desdites décisions, après avoir été signées «ne varietur» par les comparants et le notaire soussigné resteront
annexées au présent acte pour être soumises avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Lesquels comparants ont déclaré et requis le notaire instrumentaire d'acter les termes et conditions d'un projet de
fusion commun, à établir par les présentes entre les sociétés précitées par application des articles 271 1) et 278 de la loi
modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales en la forme notariée, projet dont la teneur est la suivante:
1. Description de la fusion. En tant qu'actionnaire unique, la société anonyme WORLD INVESTMENTS COMPANY,
en abrégé WIC S.A., détenant la totalité des actions de la société anonyme SATURNO S.A., entend fusionner confor-
mément aux dispositions des articles 278 et 279 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée
(ci-après désignée la «Loi»), avec la société anonyme SATURNO S.A., par absorption de cette dernière.
2. Modalités de la fusion.
2.1 La société absorbante
La société anonyme WORLD INVESTMENTS COMPANY, en abrégé WIC S.A., ayant son siège social à L-1724 Lu-
xembourg, 49, boulevard du Prince Henri, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 86.321, a été constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem,
en date du 28 janvier 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 876 du 8 juin 2002 (ci-
après dénommée «WORLD INVESTMENTS COMPANY, en abrégé WIC S.A.» ou la «société absorbante»). Les statuts
ont été modifiés plusieurs fois depuis, et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du
24 octobre 2014, en cours de publication auprès du Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
2.2 La société absorbée
La société anonyme SATURNO S.A., ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 79.951, a été constituée suivant acte reçu par
Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, en date du 15 décembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 623 du 10 août 2001 (ci-après dénommée «SATURNO S.A.» ou la «société ab-
sorbée»). Les statuts n’ont pas été modifiés depuis.
La société absorbante et la société absorbée ont été constituées et existent sous la forme de société anonyme de
droit luxembourgeois, et leur fusion est légalement possible conformément à la loi modifiée du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales telle que modifiée (la «Loi»), notamment en vertu de son article 257.
2.3. La date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable et
fiscal comme accomplies pour le compte de la société absorbante est fixée au 1
er
jour de l’exercice fiscal de la société
absorbante pendant lequel la fusion deviendra effective.
2.4. Les deux sociétés n'ont pas d'actionnaires ou porteurs de titres ayant des droits spéciaux. Les deux sociétés,
absorbante et absorbée, n'émettent actuellement pas d'emprunts obligataires.
2.5. Aucun avantage particulier n'est attribué aux membres des conseils d'administration ou aux commissaires aux
comptes des sociétés qui fusionnent du fait de la préparation et de l’exécution du présent projet de fusion.
162559
L
U X E M B O U R G
2.6. Date de prise d'effet de la fusion Tous les actionnaires de la société WORLD INVESTMENTS COMPANY, en
abrégé WIC S.A. ont le droit, pendant un mois au moins avant que la fusion ne prenne effet entre les parties, de prendre
connaissance, au siège social de cette société, des documents indiqués à l’article 267 (1) a), b) et c) de la Loi, à savoir: le
projet de fusion, les comptes annuels ainsi que les rapports de gestion du dernier exercice clôturé au 31 octobre 2013,
ainsi qu'un état comptable établi au 30 septembre 2014. Une copie intégrale ou, s'il le désire, partielle de ces documents
peut être obtenue par tout actionnaire sans frais et sur simple demande.
2.7. Un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante disposant d'au moins 5% (cinq pourcent) des actions du
capital souscrit ont le droit de requérir pendant le délai légal comme indiqué à l’article 264 c) de la Loi la convocation
d'une assemblée générale de la société absorbante appelée à se prononcer sur l’approbation de la fusion. L'assemblée
doit être convoquée de façon à être tenue dans le mois de la réquisition.
2.8. A défaut de convocation d'une assemblée ou de rejet du projet de fusion par celle-ci, la fusion deviendra définitive
un mois après la publication du présent projet de fusion au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (la «Date
de Prise d’Effet»), et entraînera de plein droit les effets prévus à l’article 274 de la loi sur les sociétés commerciales.
3. Effets de la fusion.
3.1. Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes de la société absorbée prennent fin à la Date de
Prise d’Effet. Décharge entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société absorbée.
3.2. Entre les sociétés qui fusionnent, la fusion aura effet à la Date de Prise d’Effet de telle manière que tous les actifs
et tous les passifs de la société absorbée seront censés être transférés à la société absorbante à cette date.
3.2.1. La société absorbante deviendra propriétaire des biens qui lui ont été apportés par la société absorbée dans
l’état où ceux-ci se trouvent à la date effective, sans droit de recours contre la société absorbée pour quelque raison que
ce soit.
3.2.2. La société absorbante acquittera à compter de la Date de Prise d’Effet tous impôts, contributions, taxes et
redevances, primes d'assurance et autres, tant ordinaires qu'extraordinaires, qui grèveront ou pourront grever la pro-
priété des biens apportés.
3.2.3. La société absorbante exécutera tous contrats et tous engagements de quelque nature que ce soit de la société
absorbée tels que ces contrats et engagements existent à la Date de Prise d’Effet.
3.2.4. La société absorbante assumera toutes les obligations et dettes de quelque nature que ce soit de la société
absorbée à compter de la Date de Prise d’Effet.
3.2.5. Les droits et créances compris dans le patrimoine de la société absorbée sont transférés à la société absorbante
avec toutes les garanties tant réelles que personnelles qui y sont attachées. La société absorbante sera ainsi subrogée,
sans qu'il y ait novation, dans les droits réels et personnels de la société absorbée en relation avec tous les biens et contre
tous les débiteurs sans exception.
3.3. Ainsi par l’effet de la fusion la société absorbée sera dissoute et toutes les actions qu'elle a émises seront annulées.
3.4. La société absorbante procédera à toutes les formalités nécessaires ou utiles pour donner effet à la fusion et à la
cession de tous les avoirs et obligations par la société absorbée à la société absorbante. Y sont comprises les formalités,
procédures, conditions et les publications qui sont prévues par les lois et règlements des pays étrangers dans lesquels
des biens patrimoniaux sujets à absorption sont situés. Dans toute la mesure exigée par la loi ou jugée nécessaire ou
utile, des documents de transfert appropriés seront signés par les sociétés qui fusionnent et la société absorbée apportera
tout son concours en vue de réaliser le transfert des actifs et passifs apportés par elle au profit de la société absorbante.
3.5. Le coût de l’opération de fusion sera supporté par la société absorbante. La société absorbante acquittera le cas
échéant les impôts dus par la société absorbée au titre des exercices non encore imposés définitivement.
3.6. Les documents sociaux de la société absorbée seront conservés pendant le délai légal au siège de la société
absorbante.
<i>Pouvoirsi>
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original ou d'une copie des présentes pour effectuer toutes formalités et
faire toutes déclarations, significations, dépôts, publications et autres.
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné déclare attester la légalité du présent projet de fusion, conformément aux dispositions de l’article
271 (2) de la loi sur les sociétés commerciales.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms usuels, états
et demeures, lesdits comparants ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: C. Geiben, G. Hellenbrand et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 30 octobre 2014. LAC/2014/50779. Reçu douze euros EUR 12,-
<i>Le Receveuri> (signée): Irène THILL.
162560
L
U X E M B O U R G
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 novembre 2014.
Référence de publication: 2014173359/116.
(140197632) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2014.
Rice LuxCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,02.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 180.091.
RECTIFICATIF
Il y a lieu de rectifier comme suit, dans le Mémorial C n° 3087 du 24 octobre 2014, page 148175:
Premier paragraphe au point 2, troisième tiret:
au lieu de:
"- Monsieur Matthew Grill, .....",
lire:
"- Monsieur Matthew Crill, ......".
Deuxième paragraphe, dernière ligne de la composition du conseil de gérance:
au lieu de:
"- Monsieur Matthew Orili, gérant de catégorie B",
lire:
"- Monsieur Matthew Crill, gérant de catégorie B".
Référence de publication: 2014175803/19.
Triton III LuxCo 9 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 155.500.
RECTIFICATIF
Il y a lieu de rectifier comme suit, dans le Mémorial C n° 2702 du 3 octobre 2014, page 129694:
Premier paragraphe au point 3, troisième tiret:
au lieu de:
"- Monsieur Matthew Orili, .....",
lire:
"- Monsieur Matthew Crill, ......".
Deuxième paragraphe, deuxième ligne de la composition du conseil de gérance:
au lieu de:
"- Monsieur Matthew Grill, gérant de catégorie B",
lire:
"- Monsieur Matthew Crill, gérant de catégorie B".
Référence de publication: 2014175804/19.
Saddle Luxco Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 185.017.
RECTIFICATIF
Il y a lieu de rectifier comme suit, dans le Mémorial C n° 2677 du 2 octobre 2014, page 128457:
Premier paragraphe au point 2, troisième tiret:
au lieu de:
"- Monsieur Matthew Grill, .....",
162561
L
U X E M B O U R G
lire:
"- Monsieur Matthew Crill, ......".
Deuxième paragraphe, quatrième ligne de la composition du conseil de gérance:
au lieu de:
"- Monsieur Matthew Grill, gérant de catégorie B",
lire:
"- Monsieur Matthew Crill, gérant de catégorie B".
Référence de publication: 2014175810/19.
Muha LuxCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: SEK 144.915,82.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 154.023.
RECTIFICATIF
Il y a lieu de rectifier comme suit, dans le Mémorial C n° 2653 du 1
er
octobre 2014, page 127335:
Premier paragraphe au point 2, troisième tiret:
au lieu de:
"- Monsieur Matthew Orili, .....",
lire:
"- Monsieur Matthew Crill, ......".
Deuxième paragraphe, quatrième ligne de la composition du conseil de gérance:
au lieu de:
"- Monsieur Matthew Grill, gérant de catégorie B",
lire:
"- Monsieur Matthew Crill, gérant de catégorie B".
Référence de publication: 2014175814/19.
Veresen Finance S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 30.000,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 191.520.
STATUTES
In the year two thousand and fourteen on the twenty-first of October.
Before Us Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
THERE APPEARED:
Veresen Energy Infrastructure Inc., a company duly incorporated and validly existing under the laws of Alberta, Canada,
having its principal place of business at Suite 900, Livingston Place, South Tower 222 - 3
rd
Avenue S.W., Calgary T2P0B4,
Alberta, registered with the Alberta register, under registration number 2017198512,
here represented by Mr. Regis Galiotto, notary’s clerk, with professional address at 101, rue Cents, L-1319 Luxem-
bourg, Grand Duchy of Luxembourg by virtue of a proxy given on October 16, 2014.
The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will remain
attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing person, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state as follows
the articles of association of a private limited liability company:
Art. 1. Corporate form. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which
will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August
10, 1915 on commercial companies as amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association
(hereafter the «Articles»), which set forth in Articles 6.1, 6.2, 6.5, 8 and 13 the specific rules applying to sole shareholder
companies.
Art. 2. Corporate purpose. The corporate purpose of the Company is the holding of participations, in any form
whatsoever, in other Luxembourg or foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other securities of any
162562
L
U X E M B O U R G
kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold
interests in partnerships.
The Company may borrow or lend monies in any form, in particular, but not limited to, through the entering into
credit agreements or facility agreements and proceed to the issuance of bonds, debentures or any other type of debt
securities, convertible or not, without, however, offering such bonds, debentures or debt securities to the public.
The Company may issue any type of shares, certificates or equity securities, redeemable or not, without, however,
offering them to the public.
The Company may further mortgage, pledge or otherwise encumber all or some of its assets. It may also grant any
type of guarantees and grant security interests in favor of third parties to secure its obligations or the obligations of its
subsidiaries and/or its parent(s), affiliated companies or any other companies which form part of the same group of
companies as the Company.
In a general fashion it may grant assistance to affiliated companies, take any controlling and supervisory measures and
carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.
The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on
real estate or on movable property, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.
Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. Corporate name. The Company will have the denomination “Veresen Finance S.à r.l.”.
Art. 5. Registered office. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Lu-
xembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholder(s) deliberating in the manner provided for amendments to the articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality, in the case of a sole manager, by simple
decision of the manager or, in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. Share capital - Shares.
6.1 Subscribed share capital
The share capital of the Company amounts to thirty thousand US Dollars (USD 30,000) represented by thirty thousand
(30,000) shares with a par value of one US Dollar (USD 1) each, all fully subscribed and entirely paid up.
In addition to the share capital, there may be set up a share premium account, into which any premium paid on any
share is transferred.
At the moment and as long as all the shares are held by only one shareholder, the Company is a one man company
(“société unipersonnelle”) in the meaning of article 179 (2) of the Law. In this contingency articles 200-1 and 200-2,
amongst others, will apply, this entailing that each decision of the sole shareholder and each contract concluded between
the sole shareholder and the Company represented by the sole shareholder shall have to be established in writing.
6.2 Reserve - Share Premium Account
The Company shall maintain a share premium reserve account for the Company’s shares (the “Share Premium Reserve
Account”), and there shall be recorded to such account, the amount or value of any premium paid up on the Company’s
shares.
The shareholder(s) may also resolve to increase the amount of the Share Premium Reserve Account by way of a
contribution or by incorporation of Company’s available reserves, provided that shareholder(s) representing at least half
of the Company’s share capital are present or represented at the meeting where such resolution is taken and that two
thirds of the shareholder(s) present or represented vote in favor.
Such increase may be performed without issuance of new Company’s shares as long as all the Company’s shares are
held by only one (1) shareholder.
Amounts so recorded to the Share Premium Reserve Account will constitute freely distributable reserves of the
Company for the sole benefit of the shareholder(s).
6.3 Modification of share capital
The share capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by a decision of the general
shareholders’ meeting, in accordance with article 8 of these Articles and within the limits provided for by article 199 of
the Law.
6.4 Profit participation
The shares entitle to a fraction of the Company’s assets and profits as provided by article 12 of the present Articles.
6.5 Indivisibility of shares
Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-
owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
6.6 Transfer of shares
162563
L
U X E M B O U R G
In case of a sole shareholder, the Company’s shares held by the sole shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred in compliance with
the requirements of article 189 and 190 of the Law.
6.7 Registration of shares
All shares are in registered form, in the name of a specific person, and recorded in the shareholders’ register in
accordance with article 185 of the Law.
Art. 7. Management.
7.1 Appointment and removal
The Company is managed by one (1) or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute
a board of managers, composed of manager(s) of category A and of manager(s) of category B.
Upon the appointment of any manager, other than a sole manager, that manager shall be designated by the shareholder
(s) as a category A manager or a category B manager.
If at a time when there is a sole manager, a new manager is appointed, the shareholder(s) shall, at such time, in addition
to designating the new manager as category A manager or category B manager, also designate the existing manager, to
the extent not already categorized, as a category A manager or a category B manager.
The manager(s) need(s) not be shareholder(s). The manager(s) is/are appointed and may be dismissed ad nutum by
the shareholder(s) of the Company.
7.2 Representation and signatory power
In dealing with third parties as well as legal representation, the manager(s) will have all powers to act in the name of
the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s
corporate purpose; provided that the terms of this article shall have been complied with.
The Company shall be validly committed towards third parties (i) in the case of a sole manager, by the sole signature
of its sole manager, (ii) in case of plurality of managers, by the joint signature of a manager of category A and a manager
of category B, or (iii) by the single signature of any ad hoc agent to whom such signatory power has been delegated in
accordance with the below paragraph, but only within the limits of such power.
The sole manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate all or part of his/its
powers for specific tasks to one or several ad hoc agents. The sole manager, or in case of plurality of managers, the board
of managers will determine these agents' responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of repre-
sentation and any other relevant conditions of their agency.
7.3 Powers
All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholder(s) fall within
the competence of the sole manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
7.4 Procedures
The board of managers can discuss or act validly at a meeting of the board of members only if at least a majority of
managers of the Company, including at least one of the managers of category A and one of the managers of category B,
is present or represented at the meeting of the board of managers.
In case of plurality of managers, resolutions shall be taken by a majority of the votes of the managers present or
represented at such meeting; provided that such majority shall include the vote of at least one category A manager present
or represented at the meeting and the vote of at least one category B manager present or represented at the meeting.
The managers shall designate among them a Chairperson at the beginning of each meeting of the board of managers
of the Company. The board of managers may also elect a secretary, who need not be a manager or a shareholder of the
Company, and who will be responsible for keeping the minutes of the relevant meeting of the board of managers of the
Company.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing either in writing or by fax or e-mail
another manager of the same category as proxy.
Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call
or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the
board of managers' meetings. Such approval may be in a single or in several separate documents.
7.5 Liability of managers
The manager(s) assume(s), by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly
made by him/them in the name of the Company.
Art. 8. General shareholders’ meeting. The sole shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’
meeting. The decisions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn-up in writing. Each contract entered
into between the sole shareholder and the Company represented by the sole shareholder shall be recorded in minutes
or drawn-up in writing.
162564
L
U X E M B O U R G
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number
of shares, which such shareholder owns. Each shareholder has voting rights commensurate with such shareholder’s
shareholding. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted at the majority of the votes by
shareholders owning more than half of the entire share capital.
However, resolutions to alter the Articles, except in case of a change of nationality which requires a unanimous vote,
may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarters of the Company’s entire share
capital, subject to the provisions of the Law.
The holding of general shareholders’ meetings shall not be mandatory where the number of shareholders does not
exceed twenty-five (25). In such case, each shareholder shall receive the precise wording of the text of each decision to
be adopted and shall give his vote in writing.
Art. 9. Annual general shareholders’ meeting. Where the number of shareholders exceeds twenty-five (25), an annual
general meeting of shareholders shall be held, in accordance with article 196 of the Law at the registered office of the
Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting.
Art. 10. Audit. Where the number of shareholders exceeds twenty-five (25), the operations of the Company shall be
supervised by one (1) or more statutory auditors in accordance with Article 200 of the Law who need not be shareholder.
If there is more than one (1) statutory auditor, the statutory auditors shall act as a collegium and form the board of
auditors.
Art. 11. Fiscal year - Annual accounts. The Company’s accounting year starts on the first of January and ends on the
thirty first of December of each year, with the exception of the first accounting year which begins on the date of incor-
poration of the Company and terminates on December 31, 2014.
Each year, the sole manager, or in case of a plurality of managers, the board of managers prepares an inventory, including
an indication of the value of the Company’s assets and liabilities, as well as the balance sheet and the profit and loss account
in which the necessary depreciation charges must be made.
Each shareholder may inspect, at the Company’s registered office, the above inventory, balance sheet and profit and
loss accounts and, as the case may be, the report of the statutory auditor(s) set-up in accordance with article 200 of the
Law.
Art. 12. Distribution of profits. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of
general expenses, amortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net
profit of the Company is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s
share capital.
The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion to the shareholder(s) shareholding
in the Company.
The sole manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may resolve to pay interim dividends,
including during the first financial year, subject to the drafting of an interim balance sheet showing that sufficient funds
are available for distribution. Any manager may require, at its sole discretion, to have this interim balance sheet reviewed
by an independent auditor at the Company’s expenses. The amount to be distributed may not exceed total profits since
the end of the last financial year, if existing, increased by profits carried forward and available reserves, less losses carried
forward and amount to be allocated to a reserve pursuant to the requirements of the Law or of the Articles.
Art. 13. Dissolution - Liquidation. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights,
insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders.
Except in the case of dissolution by court order, the dissolution of the Company may take place only pursuant to a
decision adopted by the general meeting of shareholders in accordance with the conditions laid down for amendments
to the Articles. At the time of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
After payment of all the debts of and charges due from the Company, including the expenses of liquidation, the net
liquidation proceeds shall be distributed to the shareholder(s) so as to achieve on an aggregate basis the same economic
result as the distribution rules set out for dividend distributions.
Art. 14. Reference to the law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific
provision is made in these Articles.
<i>Subscription - Paymenti>
The Articles having thus been established, Veresen Energy Infrastructure Inc., aforementioned declared to subscribe
the entire share capital represented by thirty thousand (30,000) shares with a par value of one US Dollar (USD 1).
All the shares have been fully paid in cash, so that the amount of thirty thousand US Dollars (USD 30,000) is at the
disposal of the Company, evidence thereof having been given to the notary.
162565
L
U X E M B O U R G
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at one thousand five hundred Euros (1,500.- EUR).
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
1. The Company will be managed by the following managers:
<i>Category A managers:i>
- Kevan King, born on August 11, 1954, in Cranbrook, British Columbia, Canada, and residing professionally at 900,
222 3
rd
Ave SW Calgary Alberta, Canada T2P0B4;
- Theresa Jang, born on August 9, 1964, in Victoria, British Columbia, Canada, and residing professionally at 900, 222
3
rd
Ave SW Calgary Alberta, Canada T2P0B4;
<i>Category B managers:i>
- Christophe-Emmanuel Sacré born on January 22, 1985 in Ottignies, Belgium, and residing professionally at 6, rue
Eugene Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
- Pierre Claudel born on May 23, 1978 in Schiltigheim, France, and residing professionally at 6, rue Eugene Ruppert,
L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and
- Ralph Heijder born on March 16, 1978 in Oss, the Netherlands, and residing professionally at 6, rue Eugene Ruppert,
L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
2. The registered office of the Company shall be established at 6, rue Eugene Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille quatorze, le vingt et un octobre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
A COMPARU:
Verezen Energy Infrastructure Inc., une société valablement constituée et existante sous le droit d’Alberta, Canada,
ayant son siège social à Suite 900, Livingston Place, South Tower 222 - 3
rd
Avenue S.W., Calgary T2P0B4, Alberta,
enregistrée auprès du registre d’Alberta sous le numéro 2017198512,
ici représentée par Mr. Regis Galiotto, clerc de notaire, avec adresse professionnelle au 101, rue Cents, L-1319 Lu-
xembourg, Grand-Duché du Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée le 16 octobre 2014.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée
aux présentes pour être formalisée avec les autorités d’enregistrement.
Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une
société à responsabilité limitée unipersonnelle:
Art. 1
er
. Forme sociale. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une
telle entité (ci-après «la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que
modifiée (ci-après «la Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en
leurs articles 6.1, 6.2, 6.5, 8 et 13, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Art. 2. Objet social. L’objet de la Société consiste en la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans
d’autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription, ou de toute autre manière
ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs
de toutes espèces, ainsi que la possession, l’administration, la mise en valeur et la gestion de ces participations.
La Société pourra également détenir des participations dans des sociétés de personnes.
La Société peut emprunter ou prêter sous quelque forme que ce soit, en particulier, mais sans limitation, par la
conclusion de contrats de crédit et procéder à l’émission d'obligations, de titres d'emprunt ou de tout autre type de titre
de créance, convertible ou non, sans toutefois offrir ces obligations, titres d'emprunt ou titres de créance au public.
La Société peut en outre octroyer à tout tiers toute sûreté ou garantie pour ses propres dettes ou obligations ou pour
les dettes ou obligations de sociétés appartenant au même groupe.
162566
L
U X E M B O U R G
La Société pourra en outre hypothéquer, nantir ou grever tout ou partie de ses actifs. Elle peut également accorder
tout type de garanties et de sûretés en faveur de tiers pour garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales et/ou
société(s) parente(s), sociétés affiliées ou toutes autres sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.
D’une manière générale, elle pourra prêter assistance à toute société affiliée, prendre toutes mesures de contrôle et
de supervision et exécuter toutes opérations qu’elle estimera utiles dans l’accomplissement et le développement de son
objet.
La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute trans-
action sur des biens mobiliers ou immobiliers, utile à l’accomplissement et au développement de son objet.
Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Dénomination sociale. La Société aura la dénomination «VERESEN FINANCE S.A R.L.».
Art. 5. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché du Luxembourg par une délibération de l’assemblée
générale extraordinaire de l’/des associé(s) délibérant comme en matière de modification des Statuts.
L'adresse du siège social peut être transférée à l’intérieur de la commune, en cas de gérant unique, par simple décision
du gérant ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l’étranger.
Art. 6. Capital social - Parts sociales.
6.1 Capital souscrit et libéré
Le capital social de la Société est fixé à trente mille US Dollars (USD 30.000) représenté par trente mille (30.000) parts
sociales d’une valeur nominale d’un US Dollar (USD 1) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.
Outre le capital social, un compte de prime d’émission peut être créé dans lequel toute prime payée sur une part
sociale est alloué.
A partir du moment et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont détenues par un seul associé, la Société est
une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la Loi. Dans la mesure où les articles 200-1 et 200-2 de la Loi
trouvent à s'appliquer, chaque décision de l’associé unique et chaque contrat conclu entre l’associé unique et la Société
représentée par l’associé unique sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit.
6.2 Prime d’émission
La Société doit maintenir un compte de prime d’émission pour les parts sociales de la Société (le «Compte de Réserve
de Prime d’Emission») et toute prime payée sur les parts sociales de la Société doit y être inscrite.
Les Associés peuvent également augmenter le montant du Compte de Réserve de Prime d’Emission par un apport ou
par incorporation de réserves de la Société pourvu que les associés représentant au moins la moitié du capital social de
la Société soient présents ou représentés à la réunion durant laquelle une telle décision est prise et que les deux tiers
des associés présents ou représentés votent en faveur.
Une telle augmentation peut être effectuée sans l’émission de parts sociales nouvelles tant que toutes les parts sociales
de la Société sont détenues par un associé unique.
Les montants ainsi enregistrés sur le Compte de Réserve de Prime d’Emission constitueront une réserve librement
disponible au seul bénéfice des associés.
6.3 Modification du capital social
Le capital social souscrit peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de
l’assemblée générale des associés conformément à l’article 8 des présents Statuts et dans les limites prévues à l’article
199 de la Loi.
6.4 Participation aux bénéfices
Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société conformément à l’article 12 des
présents Statuts.
6.5 Indivisibilité des parts sociales
Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire est admis par part sociale. Les
copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
6.6 Transfert de parts sociales
Dans l’hypothèse d’un associé unique, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chaque associé ne sont transmissibles que
sous réserve du respect des dispositions prévues aux articles 189 et 190 de la Loi.
6.7 Enregistrement des parts sociales
Toutes les parts sociales sont nominatives, au nom d'une personne déterminée et sont inscrites sur le registre des
associés conformément à l’article 185 de la Loi.
162567
L
U X E M B O U R G
Art. 7. Gérance.
7.1 Nomination et révocation
La Société est gérée par un (1) gérant unique ou par plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils consti-
tueront un conseil de gérance, composé de gérant(s) de catégorie A et de catégorie B.
Dès sa nomination, tout gérant autre que le gérant unique devra être désigné par l’associé unique ou les associés
comme étant gérant de catégorie A ou de catégorie B.
Si la Société ne compte qu’un seul gérant au moment où un second gérant est nommé, l’associé unique ou les associés,
devra/ont en plus d’indiquer la catégorie à laquelle appartient ce nouveau gérant, indiquer celle du gérant existant, au cas
où celui-ci n’aurait pas déjà été catégorisé comme gérant de catégorie A ou gérant de catégorie B.
Le(s) gérant(s) n'est/ne sont pas nécessairement associé(s). Ils sont nommés et susceptibles d’être révoqués ad nutum
par le(s) associé(s) de la Société.
7.2 Représentation et signature autorisée
Dans les rapports avec les tiers et en justice, le gérant unique, et en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance
aura tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément
à l’objet social et sous réserve du respect des termes du présent article.
La Société est engagée vis-à-vis des tiers (i) en cas de gérant unique, par la seule signature du gérant unique, (ii) en cas
de pluralité de gérants, par la signature conjointe d’un gérant de catégorie A et d’un gérant de catégorie B, ou (iii) par la
seule signature de tout mandataire ad hoc à qui un tel pouvoir de signature a été délégué conformément au paragraphe
suivant, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.
Le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour des
opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc. Le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil
de gérance déterminera les responsabilités du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de
représentation et n'importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.
7.3 Pouvoirs
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts à l’assemblée générale du/des associé
(s) relèvent de la compétence du gérant unique ou en cas de pluralité de gérants de la compétence du conseil de gérance.
7.4 Procédures
Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement lors d’une réunion de ses membres que si au moins la
majorité des gérants de la Société, incluant au moins un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B, est présente
ou représentée à la réunion du conseil de gérance.
En cas de pluralité de gérants, les résolutions ne pourront être prises qu'à la majorité des voix exprimées par les
gérants présents ou représentés à ladite réunion; à condition que cette majorité inclue la voix d’au moins un gérant de
catégorie A présent ou représenté à la réunion et celle d’au moins un gérant de catégorie B présent ou représenté à la
réunion.
Les gérants désignent parmi eux un Président au début de chaque réunion du conseil de gérance de la Société. Le
conseil de gérance peut également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être un gérant ou un associé de la Société,
et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux de la réunion du conseil de gérance de la Société. Le Président a
une voix prépondérante en cas de partage des voix.
Tout gérant peut participer aux réunions du conseil de gérance en nommant par écrit, fax ou e-mail un autre gérant
de même catégorie comme son représentant.
Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil de gérance par "conference call" via
téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant
au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé
en personne à la réunion.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision
prise lors d'une réunion du conseil de gérance. Cette approbation peut résulter d'un seul ou de plusieurs documents
distincts.
7.5 Responsabilité des gérants
Le(s) gérant(s) ne contracte(nt) en raison de sa/leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux enga-
gements régulièrement pris par lui/eux au nom de la Société
Art. 8. Assemblée générale des associés. L'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés à l’assemblée générale
des associés. Les décisions de l’associé unique sont enregistrées dans un procès-verbal ou prises par écrit. Chaque contrat
entre l’associé unique et la Société représentée par l’associé unique sera enregistré dans un procès-verbal ou pris à l’écrit.
En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de
parts qu'il détient. Chaque associé possède un droit de vote en rapport avec le nombre des parts qu’il détient. Les décisions
collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par la majorité des voix des associés
détenant plus de la moitié du capital social.
162568
L
U X E M B O U R G
Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts, sauf en cas de changement de nationalité de la Société pour lequel un
vote à l’unanimité des associés est exigé, ne peuvent être adoptées que par une majorité d'associés détenant au moins
les trois quarts du capital social de la Société, conformément aux prescriptions de la Loi.
La tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, quand le nombre des associés n'est pas supérieur à vingt-cinq
(25). Dans ce cas, chaque associé recevra le texte de chaque décision à prendre et émettra son vote par écrit.
Art. 9. Assemblée générale annuelle des associés. Si le nombre d’associés est supérieur à vingt-cinq (25), une assemblée
générale des associés doit être tenue, conformément à l’article 196 de la Loi, au siège social de la Société ou à tout autre
endroit à Luxembourg tel que précisé dans la convocation de l’assemblée.
Art. 10. Vérification des comptes. Si le nombre d’associés est supérieur à vingt-cinq (25), les opérations de la Société
sont contrôlées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes conformément à l’article 200 de la Loi, lequel ne
requiert pas qu'il(s) soi(en)t associé(s). S'il y a plus d'un (1) commissaire, les commissaires aux comptes doivent agir en
collège et former le conseil des commissaires aux comptes.
Art. 11. Exercice social - Comptes annuels. L’année sociale de la Société commence le premier janvier et se termine
le trente et un décembre de chaque année, à l’exception toutefois de la première année qui débute à la date de la formation
de la Société et se termine le 31 décembre 2014.
A la fin de chaque exercice social, le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un
inventaire (indiquant toutes les valeurs des actifs et des passifs de la Société) ainsi que le bilan, le compte de pertes et
profits, lesquels apporteront les renseignements relatifs aux charges résultant des amortissements nécessaires.
Chaque associé pourra personnellement ou par le biais d'un agent nommé à cet effet, examiner, au siège social de la
Société, l’inventaire susmentionné, le bilan, le compte de pertes et profits et le cas échéant le rapport du ou des com-
missaire(s) établi conformément à l’article 200 de la Loi.
Art. 12. Distribution des profits. Les bénéfices bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction
des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net. Il est prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice
net de la Société pour la constitution de la réserve légale jusqu’à ce que celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital
social de la Société.
Le solde des bénéfices nets peut être distribué au(x) associé(s) en proportion de leur participation dans la Société.
Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut décider de procéder au paiement
d'acomptes sur dividendes, y compris durant le premier exercice social, à condition d’établir un bilan intérimaire indiquant
que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution. Chaque gérant peut, de manière discrétionnaire, demander
que ce bilan intérimaire soit revu par un réviseur d’entreprises aux frais de la Société. Le montant distribué ne doit pas
excéder le montant des profits réalisés depuis la fin du dernier exercice social, le cas échéant, augmenté des bénéfices
reportés et du montant des réserves conformément aux exigences de la Loi ou des Statuts.
Art. 13. Dissolution - Liquidation. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils,
de l’insolvabilité ou de la faillite de l’associé unique ou d'un des associés.
Sauf dans le cas d'une dissolution par décision judiciaire, la dissolution de la Société ne peut se faire que sur décision
adoptée par l’assemblée générale des associés dans les conditions exigées pour la modification des Statuts. Au moment
de la dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par
les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunération.
Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société, y compris les frais de liquidation, le boni net de la
liquidation sera distribué à/aux associé(s), selon les mêmes règles de distribution que celles énoncées pour les distributions
de dividendes, de manière à atteindre le montant global du résultat économique.
Art. 14. Référence à la loi. Pour tous les points non expressément prévus par les présents Statuts, il est fait référence
aux dispositions de la Loi.
<i>Souscription - Libérationi>
Les Statuts ainsi établis, VERESEN ENERGY INFRASTRUCTURE INC., susnommée, déclare souscrire l’entièreté du
capital social représenté par trente mille (30.000) parts sociales d’une valeur nominale d’un US Dollar (USD 1) chacune.
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de trente
mille US Dollars (USD 30.000) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant qui le
reconnaît expressément.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont
mis à sa charge à raison de sa constitution sont estimés à environ mille cinq cents Euros (1.500.- EUR).
<i>Décisions de l'associé uniquei>
1. La Société est administrée par les gérants suivants:
162569
L
U X E M B O U R G
<i>Gérant de catégorie A:i>
- Kevan King, né le 11 août 1954, à Cranbrook, British Columbia, Canada, et demeurant professionnellement au 900,
222 3
rd
Ave SW Calgary Alberta, Canada T2P0B4;
- Theresa Jang, née le 9 août 1964, à Victoria, British Columbia, Canada, et demeurant professionnellement au 900,
222 3
rd
Ave SW Calgary Alberta, Canada T2P0B4;
<i>Gérant de catégorie B:i>
- Christophe-Emmanuel Sacré né le 22 janvier 1985 à Ottignies, Belgique, et demeurant professionnellement au 6, rue
Eugene Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
- Pierre Claudel né le 23 mai 1978 à Schiltigheim, France, et demeurant professionnellement au 6, rue Eugene Ruppert,
L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; et
- Ralph Heijder né le 16 mars 1978 à Oss, Pays-Bas, et demeurant professionnellement au 6, rue Eugene Ruppert,
L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
2. Le siège social de la Société est établi au 6, rue Eugene Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que les comparants ont requis de documenter
le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête desdits comparants, en cas de divergence
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le
notaire.
Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 octobre 2014. Relation: LAC/2014/50461. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé) I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 4 novembre 2014.
Référence de publication: 2014172467/438.
(140196371) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2014.
Cole Objekt Theresienhöhe GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 152.059.
Cole Objekt Düsseldorf GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 152.008.
VERSCHMELZUNGSPLAN - ENTWUR
ZWISCHEN DEN UNTERZEICHNENDEN PARTEIEN:
(1) GOLE OBJEKT THERESIENHöHE GMBH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Satzungssitz in Frankfurt
am Main, und Verwaltungssitz in 25A, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, mit einem Stammkapital in der Höhe von EUR
25.000 und eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter der Nummer HRB 82714 und im
Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 152059 (der "Übertragende Rechtsträger"),
UND
(2) COLE OBJEKT DÜSSELDORF GMBH, eine Gesellschaft mit beschrankter Haftung, mit Satzungssitz in Frankfurt
am Main, und Verwaltungssitz in 25A, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, mit einem Stammkapital in der Höhe von EUR
25.000 und eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter der Nummer HRB 82679 und im
Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 152008 (der "Übernehmende Rechtsträger").
Der Übertragende Rechtsträger und der Übernehmende Rechtsträger werden zusammen als "Verschmelzende Ge-
sellschaften" bezeichnet,
WOBEI:
(A) EuroSITQ, société anonyme („EuroSITQ“), mit Sitz in 25A, Boulevard Royal L-2449 Luxemburg, Großherzogtum
Luxemburg, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 83103, 18.750 Geschäftsanteile (lau-
fende Nummern 2 - 18.751) von nominal je EUR 1 des Übertragenden Rechtsträgers halt, und die EuroSITQ Finances,
société anonyme, („EuroSITQ Finances“) mit Sitz in 25A, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, Großherzogtum Luxem-
burg, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg Unter der Nummer B 85190, 6.250 Geschäftsanteile von nominal
162570
L
U X E M B O U R G
je EUR 1 (laufende Nummern 18.752 - 25.001) des Übertragenden Rechtsträgers hält. Die Stammeinlagen des Übertra-
genden Rechtsträgers sind voll eingezahlt,
(B) EuroSITQ 18.750 Geschäftsanteile (laufende Nummern 2 - 18.751) von nominal je EUR 1 des Übernehmenden
Rechtsträgers hält, und EuroSITQ Finances 6.250 Geschäftsanteile von nominal je EUR 1 (laufende Nummern 18.752 -
25.001) des Übernehmenden Rechtsträgers hält. Die Stammeinlagen des Übernehmenden Rechtsträgers sind voll
eingezahlt.
(C) Die Verschmelzenden Gesellschaften beschlossen haben, eine Verschmelzungsprozess einzuleiten, an dessen Ende
der Übernehmende Rechtsträger den Übertragende Rechtsträger aufnehmen soll, In Übereinstimmung mit den Bestim-
mungen der Sektion XIV, Unterabschnitt 1 des Luxemburger Gesetzes vom 10. August 1915 Über Handelsgesellschaften,
in seiner aktualisierten Fassung (das „Gesetz von 1915“).
(D) Die Verschmelzenden Gesellschaften daher diesen gemeinsame Verschmelzungsplan (der „VerschmelzungspIan“)
gemäß Paragraph 261 ff des Gesetzes von 1915 aufgesetzt haben und beschlossen haben, diesen Verschmelzungsplan ihren
jeweiligen Gesellschafterversammlungen, gemäß Paragraph 263 des Gesetzes von 1915, vorzulegen.
ES WIRD FOLGENDES VEREINBART:
1. Der Übertragende Rechtsträger überträgt, am Wirksarnkeitsdatum (wie nachstehend definiert) der Verschmelzung
sein Vermögen als Ganzes mit allen Rechten und Pflichten unter Ausschluss der Abwicklung im Wege der Verschmelzung
zur Aufnahme gemäß dem Gesetz von 1915 auf den Übernehmenden Rechtsträger (die „Verschmelzung“).
2. Die Verschmelzung wird an dem Tag wirksam, an dem die Verschmelzung durch die außerordentlichen Hauptver-
sammlungen der Verschmelzenden Gesellschaften in Überemstirnmung mit Artikel 272 des Gesetzes von 1915 genehmigt
wird (das „Wirksamkeitsdatum“).
3. Sofern das Wirksamkeitsdatum nicht später als der 31. Dezember 2014, 23:59 Uhr ist, wird der Verschmelzung die
Bilanz des übertragenden Rechtsträgers auf den 30. Juni 2014 als Schlussbilanz zu Grunde gelegt. Sollte das Wirksam-
keitsdatum innerhalb des Kalenderjahres 2015 liegen, wird der Verschmelzung die Bilanz des übertragenden Rechtsträgers
auf den 1. Januar 2015 als Schlussbilanz zu Grunde gelegt.
4. Der Übernehmende Rechtsträger übernimmt die Vermögensgegenstände des übertragenden Rechtsträgers unter
Zugrundelegung ihrer Nettobuch Werte, wie sie sich aus der Bilanz des übertragenden Rechtsträgers zum (i) 30. Juni
2014, sofern das Wirksamkeitsdatum nicht später als der 31. Dezember 2014, 23:59 Uhr ist, oder (ii) 1. Januar 2015,
sollte das Wirksamkeitsdatum innerhalb des Kalenderjahres 2015 liegen, in jeden Fall gemäß Punkt 7 des Verschmel-
zungsplans ergeben und fuhrt diese fort.
Der Nettoinventarwert, der das gesamte Vermögen als Ganzes mit allen Rechten und Pflichten, die der Übertragende
Rechtsträger Übertragen wird darstellt, entspricht (i) EUR 70,542,112.07, sofern das Wirksamkeitsdatum nicht später als
der 31. Dezember 2014, 23:59 Uhr ist, oder (ii) dem Betrag in Euro welcher aus der Bilanz des übertragenden Rechts-
trägers zum 1. Januar 2015 herausgeht, sollte das Wirksamkeitsdatum innerhalb des Kalenderjahres 2015 liegen.
5. Aus bilanzieller Sicht findet die Übernahme des Vermögens des übertragenden Rechtsträgers durch den Überneh-
menden Rechtsträger mit Wirkung zum (i) 1. Juli 2014, 00:00 Uhr sofern das Wirksamkeitsdatum nicht später als der 31.
Dezember 2014, 23:59 Uhr tst, oder (ii) 1. Januar 2015, sollte das Wirksamkeitsdatum innerhalb des Kalenderjahres 2015
liegen (Verschmelzungsstichtag im Sinne von Paragraph 261(2)e) des Gesetzes von 1915 (der „Verschmelzungsstichtag")).
Ab dem Wirksamkeitsdatum gelten alle Handlungen und Geschäfte des übertragenden Rechtsträgers aus bilanzieller Sicht
als von dem Übernehmenden Rechtsträger vorgenommen.
6. Das Umtauschverhältnis wird auf 100 Anteile des Übernehmenden Rechtsträgers für 25.000 Anteile des übertra-
genden Rechtsträgers festgesetzt.
7. Als Gegenleistung für die Übertragung des gesamtes Vermögens als Ganzes mit allen Rechten und Pflichten des
übertragenden Rechtsträgers, mit einem Nettoinventarwert von (i) EUR 70,542,112.07, sofern das Wirksamkeitsdatum
nicht später als der 31. Dezember 2014, 23:59 Uhr ist, oder (ii) dem Betrag in Euro welcher aus der Bilanz des übertra-
genden Rechtsträgers zum 1. Januar 2015 herausgeht, sollte das Wirksamkeitsdatum innerhalb des Kalenderjahres 2015
liegen, gewährt der Übernehmende Rechtsträger am Wirksamkeitsdatum, EuroSITQ und EuroSITQ Finances (die am
Wirksamkeitsdatum die unter Ziffer A. Hierüber benannten jeweiligen Anteïle des Übertragenden Rechtsträgers halten)
folgende Anteile:
EuroSITQ erhält 75 Anteile mit einem Nennbetrag von je EUR 1 (laufende Nummerci 25.002 -25.076); und
EuroSITQ Finances erhält 25 Anteile mit einem Nennbetrag von je EUR 1 (laufende Nummern 25.0077-25.101).
8. Nach der Verschmelzung muss den Anteilsinhabern des Übertragenden Rechtsträgers keine Ausgleichszahlung ge-
macht werden.
9. Zur Durchführung der Verschmelzung wird der Übernehmende Rechtstrager am Wirksamkeitsdatum sein Stamm-
kapital von bislang EUR 25.000 um EUR 100 auf EUR 25.100 erhöhen, und zwar durch Bildung 75 neuer Geschäftsanteile
mit einem Nennbetrag von je EUR 1 (laufende Nummern 25.002 - 25.076), welche an EuroSITQ ausgegeben werden, und
25 neuer Geschäftsanteile mit einem Nennbetrag von je EUR 1 (laufende Nummern 25.077 - 25.101), welche an EuroSITQ
Finances ausgegeben werden.
162571
L
U X E M B O U R G
10. Der Restbetrag des Nettowerts, der nicht der im obigen Absatz genannten Kapitalerhöhung zugeordnet ist, in der
Höhe von EUR 70,542,012.07 , sofern, das Wirksamkeitsdatum nicht später als der 31. Dezember 2014, 23:59 Uhr ist,
wird der Verschmelzungsprämie unter Luxemburger Recht zugeführt.
11. Die neuen, in der vorstehenden Ziffer 9. aufgeführten Anteile werden der EuroSITQ und der EuroSITQ Finances
kostenfrei und mit Gewinnberechtigung ab dem Verschmelzungsstichtag gewahrt Solche neuen Anteile werden am Wirk-
samkeitsdatum ausgestellt und im Anteilsregister des übernehmenden Rechtsträgers eingetragen.
12. Der Übernehmende Rechtstrager gewahrt keine Sonderrechte oder Vorzuge an einzelne Gesellschafter und sieht
für sie keine Maßnahmen vor. Besondere Rechte, wie Anteile ohne Stimmrecht, Vorzugsgeschaftsanteile, Mehrstimm-
rechtsgeschaüsanteile, Sonderstimmrechte, Bestellungs- oder Entsenderechte, Vorerwerbsrechte, Schuldverschreibun-
gen, Genussrechte oder sonstige besondere Rechte oder Vorzuge bestehen nicht beim Übertragenden Rechtstrager.
Daher entfällt auch die Angabe gemäß Paragraph261(2)f) des Gesetzes von 1915.
13. Es werden weder an Mitglieder eines Vertretungsorgans oder eines Aufsichtsorgans eines an der Verschmelzung
beteiligten Rechtsträgers noch an einien Geschäftsführer, den Abschlussprüfer oder einen Verschmelzungsprüfer beson-
dere Vorteile gewahrt; daher entfallen auch die diesbezüglichen, in Paragraph 261 (2)g) des Gesetzes von 1915
vorgesehenen Angaben.
14. Alle beteiligten Anteilsinhaber an dem Übertragenden und dem Übernehmenden Rechtsträger haben auf die Ers-
tattung eines Verschmelzungsberichts durch die Geschäftsführer der Verschmelzenden Gesellschaften verzichtet, so dass
gemäß Paragraph 265(3) des Gesetzes von 1915 kein Verscrimelzungsbericht erforderlich ist.
15. Alle beteiligten Anteilsinhaber an dem Übertragenden und dem Übernehmenden Rechtsträger haben auf die Ers-
tattung von Informationen in Bezug auf wichtige Änderungen ihrer Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zwischen dem
Zeitpunkt der Errichtung des Verschmelzungsplans und dem Tag der außerordentlichen Hauptversammlungen der be-
teiligten Gesellschaften In Übereinstimmung mit Paragraph 265(3) des Gesetzes von 1915, verzichtet.
16. Alle Anteilsinhaber an dem Übertragenden und dem Übernehmenden Rechtsträger haben auf ihr Recht auf Prüfung
des Verschmelzungsplans durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer und auf einen Bericht des Abschlussprüfers En
Übereinstimmung mit Paragraph 266(5) des Gesetzes von 1915 verzichtet.
17. Alle Anteilsinhaber an dem Übertragenden und dem Übernehmenden Rechtsträger haben auf ihr Recht auf den
Erhalt von Zwischenkonten der Verschmelzenden Gesellschaften In Übereinstimmung mit Paragraph 267(1) letzter Absatz
des Gesetzes von 1915 verzichtet.
18. Die Kosten dieser Verschmelzung trägt der übernehmende Rechtsträger.
19. Der Kir diesen Verschmelzungsplan maßgebliche Text ist derjenige in deutscher Sprache. Im Falle von Widers-
prüchen zwischen der deutschen und der englischen Fassung hat daher die deutsche Fassung Vorrang.
Die Verschmelzenden Gesellschaften haben diesen Verschmelzungsplan in zwei (2) Originalen ausgefertigt.
ÜBERTRA GENDER RECHTSTRAGER
COLE OBJEKT THERESIENHÖHE GMBH
Jean-Philippe Gachet / Jean-Jacques Josset
<i>Geschäftsführer / Geschäftsführer
i>ÜBERNEHMKNDER RECHSTRÄGER
COLE OBJEKT DÜSSELDORF GMBH
Jean-Pilippe Gachet / Jean-Jacques Josset
<i>Geschäftsführer / Geschäftsführeri>
There follows the English translation of the foregoing:
DRAFT TERMS OF MERGER PLAN
BETWEEN THE UNDERSIGNED PARTIES:
(1) COLE OBJEKT THERESIENHÖHE GMBH, Gesellschaft mit beschrankter Haftimg, having its corporate seat at
Frankfurt am Main, its central administration at 25A, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, having a share capital of EUR
25,000 and registered with the commercial register of Frankfurt am Main, Germany under HRB 82714 and with the
Luxembourg trade and companies register under number B 152059 (the "Transférer Legal Entity"),
AND
(2) COLE OBJEKT DÜSSELDORF GMBH, Gesellschaft mit beschrankter Haftimg, having its corporate seat at Frankfurt
am Main, its central administration at 25A, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, having a share capital of EUR 25,000
and registered with the commercial register of Frankfurt am Main, Germany under HRB 82679 and with the Luxembourg
trade and companies register under number B 152008 (the "Transferee Legal Entity").
The Transferor Legal Entity and the Transferee Legal Entity are together referred to as the "Merging Companies".
WHEREAS:
(A) EuroSITQ, société anonyme ("EuroSITQ"), having its registered office at 25A, Boulevard Royal, L-2449 Luxem-
bourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under number B
162572
L
U X E M B O U R G
83103 holds 18,750 shares (serial numbers 2- 18,751) having a nominal value of EUR 1 each in the Transférer Legal Entity
and EuroSITQ Finances, société anonyme ("EuroSITQ Finances"), having its registered office at 25A, Boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under
number B 85190 holds 6,250 shares (serial numbers 18,752 - 25,001) having a nominal value of EUR 1 each in the
Transferor Legal Entity. The shares of the Transférer Legal Entity are fully paid up.
(B) EuroSITQ holds 18,750 shares (serial numbers 2 - 18,751) having a nominal value of EUR 1 each in the Transferee
Legal Entity and EuroSITQ Finances holds 6,250 shares (serial numbers 18,752 -25,001) having a nominal value of EUR 1
each in the Transferee Legal Entity. The shares of the Transferee Legal Entity are fuliy paid up.
(C) The Merging Companies have decided to start a merger process at the end of which the Transferee Legal Entity
shall absorb the Transferor Legal Entity, according to the provisions of section XIV, sub-section 1. of the Luxembourg
act dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "Luxembourg Companies Act")-
(D) The Merging Companies have therefore drawn up this coramon merger plan (the "Merger Plan") according to
article 261 et seq. of the Luxembourg Companies Act and have decided to submit the Merger Plan to their respective
general meetings of shareholders according to article 263 of the Luxembourg Companies Act.
IT IS AGREED AS FOLLOWS:
1. The Transferor Legal Entity transfers on the Merger Effective Date (as defined below) its entire assets as a whole,
with ail rights and obligations, the Transferor Legal Entity ceasing to exist on the Merger Effective Date (as defined below)
without being wound-up, by way of merger pursuant to the Luxembourg Companies Act, to the Transferee Legal Entity
(the "Merger").
2. The Merger shall be effective at the date on which the Merger is approved by the extraordinary general meetings
of the Merging Companies in accordance with article 272 of the Luxembourg Companies Act (the "Merger Effective
Date").
3. If the Merger Effective Date is no later than 31 December 2014, 23:59 hrs, the balance sheet of the Transferor Legal
Entity as per 30 June 2014 shall be the closing balance sheet for the Merger. If the Merger Effective Date is set within the
calendar year 2015, the balance sheet of the Transferor Legal Entity as per 1 January 2015 shall be the closing balance
sheet for the Merger.
4. The Transferee Legal Entity assumes the entire assets as a whole, with ail rights and obligations, of the Transferor
Legal Entity on the basis of their net accounting values (i) as set forth in the balance sheet of the Transferor Legal Entity
as per 30 June 2014 if the Merger Effective Date is no later than 31 December 2014, 23:59 hrs or (ii) as to be set forth
in a balance sheet of the Transferor Legal Entity as at 1 January 2015 if the Merger Effective Date is set within the calendar
year 2015, in each case in accordance with item 7 of the Merger Plan and continues these net accounting values in its
accounts.
The net asset value representing the entire assets as a whole, with ail rights and obligations, transferred by the Trans-
feror Legal Entity, shall be equal (i) to EUR. 70,542,112.07 if the Merger Effective Date is no later than 31 December
2014, 23:59 hrs or (ii) the EUR amount deriving from the balance sheet of the Transferor Legal Entity as per 1 January
2015, tf the Merger Effective Date is set within the calendar year 2015.
5. From an accounting perspective, the assumption of the entire assets as a whole, with ail rights and obligations, of
the Transferor Legal Entity by the Transferee Legal Entity takes place with effect (i) as per 1 July 2014, 00:00 hrs if the
Merger Effective Date is no later than 31 December 2014, 23:59 hrs or (ii) as per 1 January 2015, 00:00 hrs if the Merger
Effective Date is set within the calendar year 2015 (effective date of the merger within the meaning of article 261 (2)e)
of the Luxembourg Companies Act (the "Merger Accounting Effective Date"). As from the Merger Accounting Effective
Date, ail actions and transactions of the Transferor Legal Entity shall be deemed, from an accounting perspective, un-
dertaken by the Transferee Legal Entity.
6. The exchange ratio is set at 100 shares of the Transferee Legal Entity for 25,000 shares of the Transferor Legal
Entity.
7. As consideration for the transfer of the entire assets as a whole, with ail rights and obligations of the Transferor
Legal Entity, having a net asset value of (i) EUR 70,542,112.07 if the Merger Effective Date is no later than 31 December
2014, 23:59 hrs or (ii) the EUR amount deriving from the balance sheet of the Transferor Legal Entity as per 1 January
2015, if the Merger Effective Date is set within the calendar year 2015, the Transferee Legal Entity issues on the Merger
Effective Date the following shares to EuroSITQ and EuroSITQ Finances (who will hold the respective numbers of shares
in the Transferor Legal Entity set out in Recital (A) above on the Merger Effective Date):
EuroSITQ receives 75 shares having a nominal value amount of EUR 1 each (serial number 25,002 -25,076); and
EuroSITQ Finances receives 25 shares having a nominal amount value of EUR 1 each (serial number 25,0077-25,101).
8. No balancing cash adjustment must be paid to the shareholders of the Transferor Legal Entity pursuant to the
Merger.
9. In order to implement the Merger, the Transferee Legal Entity increases on the Merger Effective Date its share
capital from its current amount of EUR 25,000 by EUR 100 to EUR 25,100 by creating 75 new shares having a nominal
value of EUR 1 each (serial number 25,002 - 25,076) to be issued to EuroSITQ and 25 new shares having a nominal value
of EUR 1 each (serial number 25,077 - 25,101) to be issued to EuroSITQ Finances.
162573
L
U X E M B O U R G
10. The balance of the net value that is not allocated to the share capital increase referred to in the above paragraph,
being in the amount of EUR 70,542,012.07 if the Merger Effective Date is no later than 31 December 2014, 23:59 hrs,
shall be allocated to the merger premium as far as Luxembourg law is applicable.
11. The new shares listed in item 9 above shall be issued to EuroSrTQ and EuroSITQ Finances free of charge and with
profit drawing rights as of the Merger Accounting Effective Date. Such new shares shall be issued on the Merger Effective
Date and shall be recorded subsequently in the share register of the Transferee Legal Entity.
12. The Transferee Legal Entity grants no special rights or preferences to individual shareholders and does not plan
any measures for them. Special rights, such as shares without voting rights, preference shares, multiple voting right shares,
special voting rights, appointment or secondment rights, pre-emptive purchase rights, debenture bonds, special dividend
rights or other special rights or preferences do not exist at the Transferor Legal Entity. Thus, the information pursuant
to article 261(2)f) of the Luxembourg Companies Act is dispensed with.
13. Neither members of any representative body or supervisory body of a legal entity involved in the Merger nor a
managing director, auditor or a merger auditor are granted any special advantages; hence the information pursuant to
article 261(2) g) of the Luxembourg Companies Act can also be dispensed with.
14. All shareholders in the Transferor Legal Entity and the Transferee Legal Entity have waived their right to receive
a merger report from the management of the Merging Companies, so that in accordance with article 265(3) of the
Luxembourg Companies Act, no merger report is required.
15. All shareholders in the Transferor Legal Entity and the Transferee Legal Entity have waived their right to receive
any information with respect to any important change in their assets and liabilities between the date of the establishment
of the Merger Plan and the date of the extraordinary general meetings of the Merging Companies called to resolve on
the Merger Proposal in accordance with article 265(3) of the Luxembourg Companies Act.
16. All shareholders in the Transferor Legal Entity and the Transferee Legal Entity have waived their right to have the
Merger Plan examined by an independent auditor and to receive a report of the independent auditor in accordance with
article 266(5) of the Luxembourg Companies Act.
17. All shareholders in the Transferor Legal Entity and the Transferee Legal Entity have waived their right to have
interim accounts of the Merging Companies made available to them in accordance with article 267(1) last paragraph of
the Luxembourg Companies Act.
18. The costs of mis Merger are borne by the Transferee Legal Entity.
19. For this Merger Plan the German wording shall be decisive. In case of any inconsistencies between the German
and the English wording, the German wording shall therefore prevail.
The Merging Companies have executed this Merger Plan in two (2) originals.
TRANSFEROR LEGAL ENTITY
COLE OBJEKT THERESIENHÖHE GMBH
Jean-Philippe Gachet / Jean-Jacques Josset
<i>Managing director / Managing director
i>TRANSFEREE LEGAL ENTITY
COLE OBJEKT DÜSSELDORF GMBH
Jean-Pilippe Gachet / Jean-Jacques Josset
<i>Managing director / Managing directori>
Référence de publication: 2014172692/240.
(140198083) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2014.
Finaries, Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 39.202.
L'an deux mille quatorze, le quatre novembre.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette,
S'est réunie
l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "FINARIES", établie et ayant son siège
social à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt, constituée suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire
alors de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 20 décembre 1991, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations (le «Mémorial») N° 272 du 22 juin 1992, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg
sous le numéro B 39202.
Les statuts de la société ont été modifiés en dernier lieu aux termes d'un acte reçu par Maître Blanche MOUTRIER,
préqualifiée en date du 18 mars 2011, publié au Mémorial C numéro 574 du 28 mars 2011., La séance est ouverte à 11.30
162574
L
U X E M B O U R G
heures, sous la présidence de Madame Sylviane COURTOIS, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 10A,
rue Henri M. Schnadt.
Madame la Présidente désigne comme secrétaire Madame Vanessa ROUSSEAU, demeurant professionnellement à
L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
L'assemblée désigne comme scrutateur Madame Corinne SCHILLING, demeurant professionnellement à L-2530 Lu-
xembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
La Présidente expose ensuite:
I.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, que les UN MILLION
SEPT CENT CINQUANTE MILLE (1.750.000) actions sans désignation de valeur nominale représentant l’intégralité du
capital social de HUIT MILLIONS SEPT CENT CINQUANTE MILLE EUROS (EUR 8.750.000,-) sont dûment représentées
à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut ainsi délibérer et décider valablement
sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant été convoqués et informés sur les
opérations à l’ordre du jour en date du 23 octobre 2014 par e-mail. Resteront pareillement annexées aux présentes la
liste de présence, ainsi que les procurations émanant des actionnaires représentés, lesquelles, après avoir été signées "ne
varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumentant, seront soumises avec ledit acte aux formalités de
l’enregistrement.
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
- Transformation de la dette subordonnée d’un montant de EUR 1.275.000,- envers SYCAMINE HOLDINGS B.V. en
dette non subordonnée.
- Réduction de capital par absorption des pertes reportées, par incorporation de la prime d’émission et par annulation
de 433.360 actions.
- Réduction de capital par remboursement de 1.169.158 actions détenues par SYCAMINE HOLDINGS B.V.
- Prise en compte de la modification du nombre d’actions de FINARIES et détermination de la valeur nominale de
l’action.
- Modification du premier alinéa de l’article 5 des statuts.
- Cession de la créance détenue sur la société OLFER à SYCAMINE HOLDINGS B.V. d’un montant de EUR 8.100.000,-
Après en avoir délibéré, l’assemblée adopte, à l’unanimité la résolution suivante:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale décide de transformer la dette subordonnée d’un montant de EUR 1.275.000,00 envers la société
SYCAMINE HOLDINGS B.V., société anonyme de droit néerlandais dont le siège social est établi au 651, Strawinskylaan,
NL - 1077 AMSTERDAM, enregistrée au registre de commerce (handelsregister) de Amsterdam sous le n° 33173499,
constituée lors de l’Assemblé Générale Extraordinaire du 13 décembre 2004 en dette non subordonnée. Cette dette ne
portera pas intérêt et sera transférée sur le compte courant de SYCAMINE HOLDINGS B.V. La dette existante dans les
comptes de FINARIES au 30.09.2014 sera ainsi portée de EUR 979.214,32 à EUR 2.254.214,32.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale décide de réduire le capital social de la Société par absorption des pertes reportées à concurrence
d'un montant de EUR 3.108.210,37 ressortant du bilan de la société au 31.12.2013 ainsi que d'une situation comptable
arrêtée en date du 30 septembre 2014, par annulation de la prime d’émission d’un montant de EUR 941.411,24, pour le
ramener de son montant actuel de EUR 8.750.000 à EUR 6.583.200,87 et par annulation de 433.360 actions sans dési-
gnation de valeur nominale, toutes détenues par la société SYCAMINE HOLDINGS B.V. préqualifiée.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée générale décide ensuite de réduire le capital social à concurrence de EUR 5.845.790,87 pour le ramener
de EUR 6.583.200,87 à EUR 737.410,00 par voie de remboursement de 1.169.158 actions sans désignation de valeur
nominale à son actionnaire la société SYCAMINE HOLDINGS B.V. préqualifiée.
Le remboursement audit actionnaire du montant de EUR 5.845.790,87 sera effectué par transfert sur le compte courant
de l’actionnaire portant la dette de FINARIES envers SYCAMINE HOLDINGS B.V. de EUR 2.254.214,32 à EUR
8.100.005,19.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale prend en compte la modification du nombre d’actions et constate que le capital social de FINA-
RIES est composé de 147.482 actions sans désignation de valeur.
L’assemblée générale décide de fixer la valeur nominale d’une action à EUR 5,00, le capital social se trouve alors
composé de 147.482 actions d’une valeur nominale de EUR 5,00.
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée générale décide de modifier en conséquence le premier alinéa de l’article 5 des statuts lequel aura dé-
sormais la teneur suivante:
162575
L
U X E M B O U R G
" Art. 5. (premier alinéa). Le capital social est fixé à EUR 737.410.- divisé en 147.482 actions d’une valeur nominale de
EUR 5,00.- chacune."
<i>Sixième résolutioni>
Au 04 novembre 2014, la créance détenue par FINARIES sur la fondation OLFERT DAPPER STICHTING, fondation
de droit néerlandais, ayant son siège social à NL-1077XX Amsterdam, Strawinskylaan 651, RSIN 805427363, se monte à
EUR 8.100.000.- suite au contrat de cession de créance entre FINARIES et la société COMIREG S.A. daté du 03 novembre
2014.
L’assemblée générale décide de céder la créance détenue par FINARIES sur la fondation OLFERT DAPPER STICHTING
d’une valeur de EUR 8.100.000,00 à son actionnaire SYCAMINE HOLDINGS B.V. pour une valeur de EUR 8.100.000.-,
selon les modalités fixées au projet de contrat annexé à la présente, annulant ainsi complètement la dette vis-à-vis de son
actionnaire.
Le Conseil d'Administration est mandaté aux fins d'effectuer cette compensation en respectant les prescriptions légales.
Indépendamment de toute autre disposition, la réduction de capital sera effective dans un délai de 30 jours de calendrier
suivant la publication au Mémorial du présent procès-verbal.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la Présidente lève la séance.
<i>Fraisi>
Tous les frais et honoraires, quels qu'ils soient, dus en vertu des présentes sont à la charge de la société.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par noms,
prénoms, états et demeures, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.
Signé: COURTOIS, ROUSSEAU, SCHILLING, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 05/11/2014. Relation: EAC/2014/14872. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): HALSDORF.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.
Esch-sur-Alzette, le 06 novembre 2014.
Référence de publication: 2014171941/97.
(140197084) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2014.
Advanced Asset Management SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 132.425.
EXTRAIT
L'Assemblée Générale du 30 septembre 2014 («l'Assemblée Générale») a pris acte de la démission en date du 31
décembre 2013, de Monsieur Arnaud Bouteiller.
L'Assemblée Générale a approuvé la nomination de Monsieur Andrea Salerno, en remplacement de Monsieur Bou-
teiller au sein du Conseil d'Administration, à compter du 31 décembre 2013.
L'Assemblée Générale a renouvelé les mandats des administrateurs suivants:
- Monsieur Sylvain Feraud, Administrateur et Président du Conseil d'Administration, avec adresse professionnelle 42,
rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg;
- Madame Margherita Balerna Bommartini, Administrateur, avec adresse professionnelle Via L.Zuccoli 19, CH-6900
Paradiso Lugano (Suisse);
- Monsieur Andrea Salerno, Administrateur, avec adresse professionnelle, 8 Boulevard des moulins escaliers des fleurs,
98000 Monaco.
Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2015.
L'Assemblée Générale du 30 septembre 2014 a également renouvelé le mandat du réviseur d'entreprise:
- Deloitte Audit S.à.r.L., réviseur d'entreprise, 560 Rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2015.
L’Assemblée Générale prend également acte du changement de dénomination du réviseur d’entreprise.
<i>Pour Advanced Asset Management Sicavi>
Référence de publication: 2014163710/25.
(140187342) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2014.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
162576
Advanced Asset Management SICAV
Asia Internet Holding S.à r.l.
BRE/Management 2 S.A.
BRE/Management 3 S.A.
BRE/Management 4 S.A.
BRE/Management 5 S.A.
BRE/Management 6 S.A.
BRE/Management S.A.
Castle U.S. Corporate Bonds Fund
Colada HoldCo S.à r.l.
Cole Objekt Düsseldorf GmbH
Cole Objekt Theresienhöhe GmbH
Deutsche Invest I
Deutsche Invest I
Deutsche Invest I
Deutsche Invest I
Deutsche Invest I
Deutsche Invest I
Deutsche Invest I
Deutsche Invest I
DWS Institutional
DWS Investment S.A.
Finaries
Harbour LuxCo S.à r.l.
HLSS Luxco 2A S.à r.l.
HSBC Securities Services (Luxembourg) S.A.
Immobilière Schockweiler & Bäumler S.à r.l
Infotech Project S.A.
Langley LuxCo 1 S.à.r.l.
LBLux SICAV-FIS
Muha LuxCo S.à r.l.
MUTB Non-Yen WGBI Yen-Hedged Index Fund
Observe LuxCo S.à r.l.
Premium Portfolio SICAV
Rice LuxCo S.à r.l.
Saddle Luxco Holding S.à r.l.
Saturno S.A.
Signes S.à r.l.
Swiss Alpha, SICAV
Tarpan LuxCo S.à r.l.
Timberland, SICAV
Triton III LuxCo 1 S.à r.l.
Triton III LuxCo 8 S.à r.l.
Triton III LuxCo 9 S.à r.l.
Triton III LuxCo A 16 S.à r.l.
Veresen Finance S.à.r.l.
Way LuxCo S.à r.l.
World Investments Company, en abrégé WIC S.A.