logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 3287

7 novembre 2014

SOMMAIRE

2eRRe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

157738

A.F.C. Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

157772

Calimax 2 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

157776

Campria Capital S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

157773

Campria Capital S.A. S.P.F.  . . . . . . . . . . . . .

157773

Capital Safety Group S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

157776

ColMassyRedLux Genpar  . . . . . . . . . . . . . . .

157776

ETNA Constructions s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

157775

ETNA Promotions s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

157775

Niam Core-Plus Luxembourg S.à r.l. . . . . .

157739

NW Europe Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

157744

Polyusus Lux IV S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

157752

RREEF EuCoReF 1 S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

157741

RW Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

157749

Schwartz Rolladen und Fenster GmbH . . .

157771

Terre Bleue S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

157730

Thor Trading, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

157731

Thot SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

157732

Timken Lux Holdings II S.à r.l.  . . . . . . . . . .

157731

TrendConcept Fund S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

157732

TrendConcept Fund S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

157731

Tyco Electronics Holding S.à r.l.  . . . . . . . . .

157730

UK Logistics Topco I S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

157730

UK Students 60 CR S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

157732

UL Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

157733

Universal Securitisation Solutions  . . . . . . .

157733

Upstream Systems S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

157733

Urano LuxCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

157733

Urban&Civic Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

157734

USD Rail International S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

157734

Valdabbio S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

157736

Vanille et Chocolat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

157736

VCP VII Luxco 7 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

157736

Vector Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

157734

Verne Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

157735

Villandry Conseil & Participations S.A.  . . .

157735

Vision h. s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

157735

Voirie Environnement S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

157734

VP investments Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

157735

Wen Hua S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

157737

Whitehall Bear S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

157736

Whitehall European RE 6 S.à r.l. . . . . . . . . .

157737

Whitehall European RE 7 S.à r.l. . . . . . . . . .

157737

Whitehall European RE 9 S.à r.l. . . . . . . . . .

157737

Whitehall French RE 1 S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

157738

Whitehall French RE 2 S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

157738

Whitehall French RE 3 S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

157738

Wilh. F. Schmitz Electro Technique

G.m.b.H.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

157734

Wind Infrastructure Holding S.à r.l.  . . . . .

157732

Yessod S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

157736

157729

L

U X E M B O U R G

Terre Bleue S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 96.798.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue à Luxembourg le 07 octobre 2014

L'Assemblée prend acte de la démission de Monsieur Jean-Bernard ZEIMET et de Madame Nathalie CHIARADIA de

leur poste d'administrateur ainsi que de la démission du commissaire aux comptes, la société READ SARL, RCS Luxem-
bourg B 45.083 ayant son siège social au 3A Boulevard du Prince Henri, L-1274 Luxembourg.

L'Assemblée décide de nommer en remplacement comme nouveaux administrateurs:
- Monsieur Laurent JACQUEMART, Expert-Comptable, né à Daverdisse le 19 juin 1968 et demeurant professionnel-

lement au 3A Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg

- Monsieur Eugenio RODRIGUES, Comptable, né à Metz, le 16 février 1976 et demeurant professionnellement au 3A

Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg

et comme nouveau commissaire:
-  La  société  AUDITEX  SARL  ayant  son  siège  social  au  3A  Boulevard  du  Prince  Henri,  L-1724  Luxembourg,  RCS

Luxembourg B 91.559.

Leur mandat se terminera à l'issue de l'assemblée générale statutaire à tenir en 2016.

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2014156985/23.
(140177477) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

Tyco Electronics Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 582.506.421,50.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 17, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 122.078.

Avec effet au 25 septembre 2014, TE Connectivity Holding International II S.à r.l. a transféré la totalité des 829.762.441

parts sociales A et 554.173.522 parts sociales B à TE Connectivity Holding Coöperatief U.A. déjà associé de la Société.

Par ailleurs et avec effet au 30 septembre 2014, Anne-Marie Nicolas n'est plus gérant de la Société.
Le conseil de gérance est désormais composé comme suit:
- Harold G. Barksdale,
- Juerg Frischknecht,
- Jürg Giraudi,
- Thomas Ernst,
- Fabienne Roger-Eck, et
- Magnus Svensson.

POUR EXTRAIT CONFORME ET SINCERE
Tyco Electronics Holding S.à r.l.
Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2014156981/22.
(140178038) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

UK Logistics Topco I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 166.408.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014157002/9.
(140177772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

157730

L

U X E M B O U R G

Timken Lux Holdings II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 50.004,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 166.164.

EXTRAIT

Il résulte des décisions prises par l'associée unique de la Société en date du 30 septembre 2014 que:
1. Monsieur Philip Dominic FRACASSA a démissionné de son poste de gérant de catégorie A de la Société, avec effet

au 1 

er

 octobre 2014.

2. Madame Shelly Marie CHADWICK né le 15 décembre 1971 à Massachusetts, Etats-Unis d'Amérique, demeurant

professionnellement au 4500 Mount Pleasant St. NW, North Canton, 44720 Ohio, Etats-Unis d'Amérique, a été nommé
en tant que gérant de catégorie A de la Société, avec effet au 1 

er

 octobre 2014 et ce pour une durée indéterminée.

Suite aux résolutions qui précèdent, le conseil de gérance se compose dorénavant comme suit:
Madame Shelly Marie CHADWICK, gérant de catégorie A;
Monsieur Christian A.SANWALD, gérant de catégorie A;
Monsieur Scott McKINLAY, gérant de catégorie B;
Monsieur Marc CHONG KAN, gérant de catégorie B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 octobre 2014.

Référence de publication: 2014156977/22.
(140177758) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

Thor Trading, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 16A, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 83.571.

Les comptes annuels clos au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014156989/10.
(140178217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

TrendConcept Fund S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 2, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 69.951.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Auszug

Die  «Mise  en  Liquidation»  der  Gesellschaft  wurde  im  Rahmen  einer  ausserordentlichen  Generalversammlung  mit

Datum 24. Januar 2014 vor Notar Maitre Henri Hellinckx, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, beschlossen und im Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 900 vom 08. April 2014 veröffentlicht.

Aufgrund Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 22. August 2014 wurde die Liquidation abges-

chlossen und somit ist die Gesellschaft aufgelöst und hat aufgehört zu existieren.

Die Bücher und Dokumente der Gesellschaft werden für die Dauer von mindestens fünf (5) Jahren ab dem Zeitpunkt

der Veröffentlichung dieses Auszugs im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, am Gesellschaftssitz der Hauck
&amp; Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., welche ansässig ist 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, aufbewahrt
werden.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Munsbach, den 10. September 2014.

<i>Für TrendConcept Fund S.A., en liquidation volontaire
Ein Bevollmächtigter

Référence de publication: 2014156994/22.
(140178002) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

157731

L

U X E M B O U R G

TrendConcept Fund S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 2, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 69.951.

Die Bilanz zum 31. Dezember 2013 und die Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember 2013 abgelaufene

Geschäftsjahr wurden beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Munsbach, den 10. September 2014.

<i>Für TrendConcept Fund S.A., en liquidation volontaire
Ein Bevollmächtigter

Référence de publication: 2014156996/13.
(140178004) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

Thot SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 130.859.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 7 octobre 2014

que:

- L'assemblée décide d'élire comme nouvel administrateur Monsieur Xavier SOULARD, administrateur de sociétés

demeurant 24, rue Astrid L-1143 Luxembourg en remplacement de Monsieur Renato PICCIOTTO démissionnaire.

La durée de son mandat est fixée à 6 ans et prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale des actionnaires qui se tiendra

en 2020 et qui statuera sur le bilan de l'exercice juillet 2019/ juin 2020.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 octobre 2014.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014156990/19.
(140177723) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

UK Students 60 CR S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 15.000,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 173.529.

Les comptes annuels pour la période du 11 décembre 2012 (date de constitution) au 30 juin 2013 ont été déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 octobre 2014.

Référence de publication: 2014157003/11.
(140178057) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

Wind Infrastructure Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 174.976.

Les comptes annuels pour la période du 31 janvier 2013 (date de constitution) au 31 décembre 2013 ont été déposés

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 octobre 2014.

Référence de publication: 2014157034/11.
(140178258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

157732

L

U X E M B O U R G

Universal Securitisation Solutions, Société Anonyme.

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 15, rue de Flaxweiler.

R.C.S. Luxembourg B 154.470.

Die ordentliche Generalversammlung hat am 07. Oktober 2014 beschlossen, Herrn Alain Nati, Herrn Erich Hein und

Herrn Stefan Rockel als Verwaltungsratsmitglieder wiederzuwählen. Die Mandate enden mit der Generalversammlung
des Jahres 2015.

Die Verwaltungsratsmitglieder sind nunmehr unter der Anschrift 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher beruflich

ansässig.

Ferner hat die ordentliche Generalversammlung am 07. Oktober 2014 beschlossen, PricewaterhouseCoopers, Société

Coopérative, 400, route d'Esch, L-1014 Luxembourg (RCS Luxembourg B 65477) zum Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft
zu wählen. Das Mandat endet mit der Generalversammlung des Jahres 2015.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Grevenmacher, den 07. Oktober 2014.

<i>Für die Universal Securitisation Solutions S.A.
Alain Nati / Saskia Sander

Référence de publication: 2014156998/19.
(140177764) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

Upstream Systems S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 167.915.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 octobre 2014.

Référence de publication: 2014156999/10.
(140178253) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

Urano LuxCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 178.378.

<i>Extrait du contrat de cession de parts de la Société, daté du 7 juillet 2014

En vertu de l'acte de transfert de parts, daté du 7 juillet 2014, la société Helios Investors II, Africa Ltd., ayant son siège

social à Alexander House, 3 

ème

 étage, MS-Ebène, Ile Maurice, a transféré les parts suivantes détenues dans la Société:

- 295 parts sociales
à Urano Co-Investment Partners L.P., ayant son siège social à South Church Street, KY, Grand Cayman, Iles Caïmanes
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 octobre 2014.

<i>Mandataire

Référence de publication: 2014157000/16.
(140177766) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

UL Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 136.228.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014157005/9.
(140177547) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

157733

L

U X E M B O U R G

Urban&amp;Civic Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 1.500.000,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 148.992.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 08 octobre 2014.

Référence de publication: 2014157001/10.
(140177971) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

USD Rail International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: CAD 40.000,00.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 181.698.

EXTRAIT

Le 19 décembre 2013 la forme sociale de l'associé unique de la Société a été modifiée en "limited partnership", et la

dénomination sociale de l'associé unique est désormais "USD Rail LP".

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 octobre 2014.

<i>Pour USD Rail International S.à r.l.

Référence de publication: 2014157008/14.
(140177639) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

Vector Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 132.303.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014157009/9.
(140178183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

Voirie Environnement S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5408 Bous, 60, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 152.527.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014157017/10.
(140177755) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

Wilh. F. Schmitz Electro Technique G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6633 Wasserbillig, 21, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 140.245.

Der Jahresabschluss per 31-12-2012 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Unterschrift
<i>Die Verwaltung

Référence de publication: 2014157039/11.
(140177872) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

157734

L

U X E M B O U R G

Verne Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 14.027,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 136.573.

EXTRAIT

Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales en date du 15 septembre 2014 entre la société Tomlin Equities Ltd.

et la société Verne Datacenter Ltd., une société des Bahamas ayant son siège social au 102 Saffrey Square, Bay Street and
Bank Lane, BS-13937 Nassau enregistrée sous le numéro 170590B, que la société Tomlin Equities Ltd. à cédé la totalité
de ses parts sociales soit 6.710 de ses parts sociales à la société Verne Datacenter.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme,

Luxembourg, le 08 Octobre 2014.

Référence de publication: 2014157010/16.
(140177936) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

Villandry Conseil &amp; Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 20, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 74.129.

<i>Extrait des décisions prises par l'administrateur unique le 29 septembre 2014

1- Le siège social de la société est transféré, avec effet au 28 août 2014, de son adresse actuelle 25 Route d'Esch,

L-1470 Luxembourg au 20 avenue Pasteur L-2310 Luxembourg

2- Le changement d'adresse professionnelle de l'administrateur unique:
- Monsieur Renaud FLORENT, Administrateur unique, demeurant professionnellement au 20 avenue Pasteur L-2310

Luxembourg

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2014157015/14.
(140177395) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

Vision h. s.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-4024 Esch-sur-Alzette, 371, route de Belval.

R.C.S. Luxembourg B 141.037.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 08/10/2014.

G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg

Référence de publication: 2014157016/12.
(140177774) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

VP investments Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5670 Altwies, 12, route de Mondorf.

R.C.S. Luxembourg B 179.933.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 07/10/2014.

G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg

Référence de publication: 2014157024/12.
(140177391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

157735

L

U X E M B O U R G

Valdabbio S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 53, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 151.936.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014157019/9.
(140178188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

Vanille et Chocolat, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 457, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 154.613.

Les comptes annuels au 31.12.13 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014157020/10.
(140178245) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

VCP VII Luxco 7 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 13.400,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 156.879.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 octobre 2014.

Référence de publication: 2014157021/10.
(140178123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

Whitehall Bear S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 137.548.

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires, tenue en date du 28 août 2014, a décidé d'accepter:
- la nomination avec effet au 18 août 2014 et pour une durée indéterminée, en qualité de gérant de la Société de Sam

Agnew, ayant son adresse professionnelle au Peterborough Court, 133 Fleet Street, EC4A 2BB London, Royaume-Uni

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société
Marielle STIJGER
<i>Gérante

Référence de publication: 2014157026/15.
(140177444) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

Yessod S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 178.373.

Le bilan au 31/12/2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 octobre 2014.

Référence de publication: 2014157049/10.
(140177375) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

157736

L

U X E M B O U R G

Whitehall European RE 6 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.264.525,00.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 128.510.

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires, tenue en date du 28 août 2014, a décidé d'accepter:
- la nomination avec effet au 18 août 2014 et pour une durée indéterminée, en qualité de gérant de la Société de Sam

Agnew, ayant son adresse professionnelle au Peterborough Court, 133 Fleet Street, EC4A 2BB London, Royaume-Uni

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société
Marielle STIJGER
<i>Gérante

Référence de publication: 2014157027/15.
(140177448) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

Whitehall European RE 7 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 707.071,85.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 133.478.

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires, tenue en date du 28 août 2014, a décidé d'accepter:
- la nomination avec effet au 18 août 2014 et pour une durée indéterminée, en qualité de gérant de la Société de Sam

Agnew, ayant son adresse professionnelle au Peterborough Court, 133 Fleet Street, EC4A 2BB London, Royaume-Uni

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société
Marielle STIJGER
<i>Gérante

Référence de publication: 2014157028/15.
(140177449) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

Whitehall European RE 9 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 133.480.

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires, tenue en date du 28 août 2014, a décidé d'accepter:
- la nomination avec effet au 18 août 2014 et pour une durée indéterminée, en qualité de gérant de la Société de Sam

Agnew, ayant son adresse professionnelle au Peterborough Court, 133 Fleet Street, EC4A 2BB London, Royaume-Uni

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société
Marielle STIJGER
<i>Gérante

Référence de publication: 2014157029/15.
(140177625) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

Wen Hua S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9414 Vianden, 13, rue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg B 152.317.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014157036/9.
(140177677) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

157737

L

U X E M B O U R G

Whitehall French RE 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 135.738,48.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 109.601.

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires, tenue en date du 28 août 2014, a décidé d'accepter:
- la nomination avec effet au 18 août 2014 et pour une durée indéterminée, en qualité de gérant de la Société de Sam

Agnew, ayant son adresse professionnelle au Peterborough Court, 133 Fleet Street, EC4A 2BB London, Royaume-Uni

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société
Marielle STIJGER
<i>Gérante

Référence de publication: 2014157030/15.
(140177628) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

Whitehall French RE 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 246.418,26.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 109.602.

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires, tenue en date du 28 août 2014, a décidé d'accepter:
- la nomination avec effet au 18 août 2014 et pour une durée indéterminée, en qualité de gérant de la Société de Sam

Agnew, ayant son adresse professionnelle au Peterborough Court, 133 Fleet Street, EC4A 2BB London, Royaume-Uni

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société
Marielle STIJGER
<i>Gérante

Référence de publication: 2014157031/15.
(140177627) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

Whitehall French RE 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 246.418,26.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 109.603.

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires, tenue en date du 28 août 2014, a décidé d'accepter:
- la nomination avec effet au 18 août 2014 et pour une durée indéterminée, en qualité de gérant de la Société de Sam

Agnew, ayant son adresse professionnelle au Peterborough Court, 133 Fleet Street, EC4A 2BB London, Royaume-Uni

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société
Marielle STIJGER
<i>Gérante

Référence de publication: 2014157032/15.
(140177626) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

2eRRe, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6751 Grevenmacher, 8, Leitschbach.

R.C.S. Luxembourg B 51.226.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014157055/9.
(140178262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

157738

L

U X E M B O U R G

Niam Core-Plus Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.356.647,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 172.337.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-sixth day of September;
Before Maître Martine SCHAEFFER Civil Law Notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, the

Undersigned, acting instead and place of Maître Joseph ELVINGER, Civil Law Notary, residing in Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, temporarily unavailable, who will hold the present deed.

THERE APPEARED:

Niam Lux Management S.à r.l., a société à responsabilité limitée existing under the laws of Luxembourg, whose regis-

tered office is at 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg and which is registered with the trade and companies
register under number B 169272, acting in its own name and on behalf of Niam Nordic Core-Plus, a fonds commun de
placement existing under the law of Luxembourg (the "Sole Shareholder"),

in its capacity as Sole Shareholder of Niam Core-Plus Luxembourg S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its

registered office at 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of
Commerce and Companies under number B 172337 (the "Company") and, incorporated pursuant to a deed of Me Jean-
Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, dated 19 October 2012, whose articles of
incorporation have been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") yet (the
"Articles") on 27 November 2012, number 2874, page 137934. The Articles have been amended the last time pursuant
to a deed of the undersigned notary, dated 27 August 2014 and not published in the Mémorial yet.

The Sole Shareholder is represented by Sara Lecomte, private employee, residing professionally in Luxembourg by

virtue of one proxy given under private seal, which, signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary,
will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The Sole Shareholder, acting in its capacity as sole shareholder of the Company and represented as stated here above,

hereby passes the following written resolutions in accordance with the provisions of article 200-2 of the Luxembourg
law of August 10 

th

 , 1915 on commercial companies, as amended from time to time:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of thirteen thousand four

hundred seventy-nine euro (EUR 13,479.-) so as to raise it from its present amount of two million three hundred forty-
three  thousand  one  hundred  sixty-eight  euro  (EUR  2,343,168.-)  to  two  million  three  hundred  fifty-six  thousand  six
hundred forty-seven euro (EUR 2,356,647.-) by the issue of thirteen thousand four hundred seventy-nine (13,479) shares
with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each and having the rights and obligations set out in the Articles (the "New
Shares"), each of such New Shares being paid up by way of contribution in cash of an aggregate amount of one million
three hundred forty-seven thousand eight hundred eighty-six euro and thirty-three cents (EUR 1,347,886.33).

<i>Subscription and Payment

The Sole Shareholder declares to subscribe to the New Shares, fully paid up by a contribution in cash of an aggregate

amount of one million three hundred forty-seven thousand eight hundred eighty-six euro and thirty-three cents (EUR
1,347,886.33) of which the amount of thirteen thousand four hundred seventy-nine euro (EUR 13,479.-) is allocated to
the share capital and the amount of one million three hundred thirty-four thousand four hundred seven euro and thirty-
three cents (EUR 1,334,407.33) is allocated to the share premium account of the Company (the "Contribution in Cash").

The funds corresponding to the Contribution in Cash are now at the disposal of the Company, proof of which had

been produced to the undersigned notary.

<i>Second resolution

Further to the above resolution, the Sole Shareholder resolves to amend the first paragraph of article 5 of the Articles

which shall now read as follows:

Art. 5.1. The corporate capital is fixed at two million three hundred fifty-six thousand six hundred forty-seven euro

(EUR 2,356,647.-) represented by at two million three hundred fifty-six thousand six hundred forty-seven (2,356,647)
shares having each a nominal value of one euro (EUR 1.-) each (hereafter referred to as the "Shares"). The holders of the
Shares are together referred to as the "Shareholders" and each a "Shareholder".

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above

appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
party, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

157739

L

U X E M B O U R G

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately two thousand three hundred euros (EUR 2,300.-).

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the mandatory of the appearing party, acting as said before, known to the notary

by name, first name, civil status and residence, the said mandatory has signed with Us, the notary, the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède

L'an deux mille quatorze, le vingt-sixième jour de septembre;
Par devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussi-

gnée, agissant en remplacement de Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément
empêché, qui restera dépositaire des présentes

A COMPARU:

Niam Lux Management S.à r.l., une société à responsabilité de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 2-8,

avenue Charles de Gaulle et immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 169272,
agissant pour son propre compte et au nom de Niam Nordic Core-Plus, un fonds commun de placement existant sous
les lois de Luxembourg (l’"Associé Unique"),

en tant qu'Associé Unique de Niam Core-Plus Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège

social au 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 172337 (la "Société") et constituée suivant acte de Me Jean-Joseph Wagner, notaire de
résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 19 octobre 2012, dont les statuts (les "Statuts") ont été
publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial") le 27 novembre 2012, numéro 2874, page
137934. Les Statuts ont été modifiés pour la dernière fois en vertu d'un acte du notaire soussigné, en date du 27 août
2014, pas encore publié au Mémorial.

L'Associé Unique est représenté par Sara Lecomte, employée privée, résidant professionnellement à Luxembourg, en

vertu d'une procuration qui a été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire soussigné et qui
restera annexée au présent acte afin d'être soumise aux mêmes formalités d'enregistrement.

L'Associé Unique agissant en tant qu'associé unique de la Société et représenté comme indiqué ci-dessus, prend les

résolutions suivantes conformément aux dispositions de l’article 200-2 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés com-
merciales du 10 août 1915, telle que modifiée le cas échéant:

<i>Première résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de treize mille quatre cent soixante-

dix-neuf euros (EUR 13.479,-) afin de porter son montant actuel de deux millions trois cent quarante-trois mille cent
soixante-huit euros (EUR 2.343.168,-) à deux millions trois cent cinquante-six mille six cent quarante-sept euros (EUR
2,356,647.-) par l’émission de treize mille quatre cent soixante-dix-neuf (13,479) parts sociales d'une valeur nominale d'un
euro (EUR 1,-) chacune ayant les droits et obligations définis dans les Statuts (les "Nouvelles Parts Sociales"), chacune de
ces Nouvelles Parts Sociales étant libérée au moyen d'un apport en numéraire d'un montant total d'un million trois cent
quarante-sept mille huit cent quatre-vingt-six euros et trente-trois centimes (EUR 1.347.886,33).

<i>Souscription et Paiement

L'Associé Unique déclare souscrire aux Nouvelles Parts Sociales entièrement libérées par un apport en numéraire

d'un montant total d'un million trois cent quarante-sept mille huit cent quatre-vingt-six euros et trente-trois centimes
(EUR 1.347.886,33) dont le montant de treize mille quatre cent soixante-dix-neuf euros (EUR 13.479,-) est alloué au
capital social et le montant d'un million trois cent trente-quatre mille quatre cent sept euros et trente-trois centimes
(EUR 1.334.407,33) est alloué au compte de prime d'émission de la Société (l’"Apport en Numéraire").

Les fonds correspondant à cet Apport en Numéraire sont maintenant à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé

au notaire soussigné.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution ci-dessus, l’Associé Unique décide de modifier le premier paragraphe de l’article 5 des Statuts de

la Société, qui se lira désormais comme suit:

Art. 5.1. Le capital social souscrit est fixé à deux millions trois cent cinquante-six mille six cent quarante-sept euros

(EUR 2,356,647.-) représenté par à deux millions trois cent cinquante-six mille six cent quarante-sept parts sociales (les
«Parts Sociales»), ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune. Les détenteurs de Parts Sociales sont définis
ci-après comme les «Associés», et individuellement un "Associé"."

157740

L

U X E M B O U R G

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais et le français, déclare par les présentes, qu'à la requête de la partie

comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même partie comparante,
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de deux mille trois cents euros (EUR 2.300,-).

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte à la mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connue du notaire

par nom, prénom, état civil et domicile, ladite mandataire a signé avec Nous, le notaire, le présent acte.

Signé: S. LECOMTE, M. SCHAEFFER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils le 1 

er

 octobre 2014. Relation: LAC/2014/45546. Reçu soixante-quinze euros

(EUR 75,-).

<i>Le Receveur

 (signé): I. THILL.

Référence de publication: 2014156092/123.
(140176940) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2014.

RREEF EuCoReF 1 S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 82.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 161.436.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-fifth day of September.
Before Us, Maître Francis Kesseler, notary, residing in Esch-sur-Alzette (Grand Duchy of Luxembourg).

Appeared the following:

RREEF Spezial Invest GmbH, a company incorporated under the laws of Germany, with registered office at Mainzer

Landstraße 178-190, 60327 Frankfurt am Main, Germany, registered with the commercial register at the local court of
Frankfurt am Main under the number 44003 (hereafter referred to as the "Sole Shareholder"),

hereby represented by Mrs. Sophie Henryon, residing professionally at 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette

(Grand Duchy of Luxembourg), by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as above stated, declared that it currently holds all the shares issued by RREEF

EuCoReF 1 S.à.r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 46A,
Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and
Companies Register under number B 161436, and with a share capital of ninety two thousand five hundred euro (EUR
92,500.-), incorporated by a deed of Maître Léonie Grethen, notary residing in Luxembourg, on 7 June 2011, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under the number 1994 dated 30 August 2011 (the "Company").
The articles of association of the Company have been amended for the last time by a deed of Maître Francis Kesseler,
notary residing in Luxembourg, on 27 September 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
under the number 3156 dated 12 December 2013 (the "Articles of Assocation").

The appearing party, represented as above mentioned, has been fully informed of the resolutions to be taken on the

basis of the following agenda:

<i>Agenda

1. To decrease the Company's subscribed and paid-up share capital by an amount of ten thousand euro (EUR 10,000.-)

by way of redemption and cancellation of all ten thousand (10,000) class H shares having a par value of one euro (EUR
1.-) each in accordance with the Company's Articles of Association, so as to reduce the Company's share capital from
its current amount of ninety two thousand five hundred euro (EUR 92,500.-), divided into twelve thousand five hundred
(12,500) ordinary shares, ten thousand (10,000) class A shares, ten thousand (10,000) class B shares, ten thousand (10,000)
class C shares, ten thousand (10,000) class D shares, ten thousand (10,000) class E shares, ten thousand (10,000) class F
shares, ten thousand (10,000) class G shares and ten thousand (10,000) class H shares with a par value of one euro (EUR
1.-) each to an amount of eighty two thousand five hundred euro (EUR 82,500.-) divided into twelve thousand five hundred
(12,500) ordinary shares, ten thousand (10,000) class A shares, ten thousand (10,000) class B shares, ten thousand (10,000)
class C shares, ten thousand (10,000) class D shares, ten thousand (10,000) class E shares, ten thousand (10,000) class F
shares and ten thousand (10,000) class G shares with a par value of one euro (EUR 1.-) each and to pay a redemption
price of EUR 1,708,594.74 to the Company's Sole Shareholder.

157741

L

U X E M B O U R G

2. To amend article 5 paragraph 1 of the Articles of Association of the Company so as to reflect the resolution to be

adopted under item 1 above.

3. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and

authority given to any manager of the Company, each individually, to proceed in the name and on behalf of the Company
with the registration of the redemption of the shares in the register of shareholders of the Company.

4. Miscellaneous.
The appearing party, represented as above mentioned, in its capacity as Sole Shareholder of the Company, has re-

quested the undersigned notary to document the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolved to decrease the Company's subscribed and paid-up share capital by an amount of ten

thousand euro (EUR 10,000.-) by way of redemption and cancellation of all ten thousand (10,000) class H shares having
a par value of one euro (EUR 1.-) each in accordance with the Company's Articles of Association, so as to reduce the
Company's share capital from its current amount of ninety two thousand five hundred euro (EUR 92,500.-), divided into
twelve thousand five hundred (12,500) ordinary shares, ten thousand (10,000) class A shares, ten thousand (10,000) class
B shares, ten thousand (10,000) class C shares, ten thousand (10,000) class D shares, ten thousand (10,000) class E shares,
ten thousand (10,000) class F shares, ten thousand (10,000) class G shares and ten thousand (10,000) class H shares with
a par value of one euro (EUR 1.-) each to an amount of eighty two thousand five hundred euro (EUR 82,500.-) divided
into twelve thousand five hundred (12,500) ordinary shares, ten thousand (10,000) class A shares, ten thousand (10,000)
class B shares, ten thousand (10,000) class C shares, ten thousand (10,000) class D shares, ten thousand (10,000) class E
shares, ten thousand (10,000) class F shares and ten thousand (10,000) class G shares with a par value of one euro (EUR
1.-) each and to pay a redemption price of EUR 1,708,594.74 to the Company's Sole Shareholder.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolved to amend article 5 paragraph 1 of the Company’s Articles of Association, which shall

forthwith read as follows:

"The share capital of the Company is set at eighty two thousand five hundred Euro (EUR 82,500.-) divided into twelve

thousand five hundred (12,500) ordinary shares, ten thousand (10,000) class A shares, ten thousand (10,000) class B
shares, ten thousand (10,000) class C shares, ten thousand (10,000) class D shares, ten thousand (10,000) class E shares,
ten thousand (10,000) class F shares and ten thousand (10,000) class G shares with a par value of one euro (EUR 1.-)
each."

<i>Third resolution

The Sole Shareholder resolved to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above

changes and empowers and authorizes any manager, each individually, to proceed in the name and on behalf of the
Company with the registration of the redemption of the shares in the register of shareholders of the Company.

<i>Declaration

Whereof the present notarial deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the date named at the beginning of this

document.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that, on request of the appearing party, the present

deed is drafted in English, followed by a German version and that, in case of any difference between the English and the
German text, the English text shall prevail.

The document having been read to the appearing party's proxyholder, who is known to the notary by his surname,

first name, civil status and residence, the said person signed together with the notary, this original deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendvierzehn, am fünfundzwanzigsten September
Vor Uns, Maître Francis Kesseler, Notar, mit Amtssitz in Esch-sur-Alzette (Großherzogtum Luxemburg),

Ist erschienen:

RREEF Spezial Invest GmbH, eine unter deutschem Recht gegründete Gesellschaft mit eingetragenem Sitz in der Main-

zer  Landstraße  178-190,  60327  Frankfurt  am  Main,  Deutschland,  eingetragen  im  Handelsregister  des  Amtsgerichts
Frankfurt am Main unter der Nummer 44003 (hiernach als die "Alleingesellschafterin" bezeichnet), hier vertreten durch
Frau Sophie Henryon, Privatangestellte, berufsansässig in rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette (Großherzogtum
Luxemburg), aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht.

Die vorgenannte Vollmacht bleibt zur Eintragung an diese Urkunde angeheftet.
Die erschienene Partei, vertreten wie oben erwähnt, erklärte, dass sie gegenwärtig alle ausgegebenen Anteile von

RREEF EuCoReF 1 S.à.r.l. besitzt, eine unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründete Gesellschaft mit
beschränkter  Haftung  (société  à  responsabilité  limitée)  mit  eingetragenem  Sitz  in  46A,  Avenue  J.F.  Kennedy,  L-1855
Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister unter der

157742

L

U X E M B O U R G

Nummer B 161436, mit einem Stammkapital von zweiundneunzigtausendfünfhundert Euro (EUR 92.500,-), gegründet
gemäß notarieller Urkunde von Léonie Grethen, Notarin ansässig in Luxemburg, vom 7. Juni 2011, im Mémorial C, Recueil
des  Sociétés  et  Associations  Nummer  1994  am  30.  August  2011  veröffentlicht  (die  "Gesellschaft").  Die  Satzung  der
Gesellschaft ist das letzte Mal gemäß notarieller Urkunde von Francis Kesseler, Notar ansässig in Luxemburg, vom 27.
September 2013, im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 3156 am 12. Dezember 2013 veröffent-
licht, abgeändert worden (die "Satzung").

Die erschienene Partei, vertreten wie oben erwähnt, ist vollständig über die auf Grundlage folgender Tagesordnung

zu treffenden Beschlüsse informiert worden:

<i>Tagesordnung

1. Herabsetzung des gezeichneten und eingezahlten Stammkapitals der Gesellschaft um einen Betrag von zehntausend

Euro (EUR 10.000,-), durch Rückkauf und Annullierung von sämtlichen zehntausend (10.000) Kategorie H Anteilen mit
einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1,-) gemäß der Satzung der Gesellschaft, um somit das Stammkapital der
Gesellschaft von seinem gegenwärtigen Betrag von zweiundneunzigtausendfünfhundert Euro (EUR 92.500,-), unterteilt in
zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteile, zehntausend (10.000) Kategorie A Anteile, zehntausend (10.000) Kate-
gorie  B  Anteile,  zehntausend  (10.000)  Kategorie  C  Anteile,  zehntausend  (10.000)  Kategorie  D  Anteile,  zehntausend
(10.000) Kategorie E Anteile, zehntausend (10.000) Kategorie F Anteile, zehntausend (10.000) Kategorie G Anteile und
zehntausend  (10.000)  Kategorie  H  Anteile  mit  einem  Nennwert  von  je  einem  Euro  (EUR  1,-),  auf  einen  Betrag  von
zweiundachtzigtausendfünfhundert Euro (EUR 82.500,-), unterteilt in zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteile,
zehntausend (10.000) Kategorie A Anteile, zehntausend (10.000) Kategorie B Anteile, zehntausend (10.000) Kategorie C
Anteile,  zehntausend  (10.000) Kategorie D  Anteile,  zehntausend (10.000) Kategorie E Anteile,  zehntausend  (10.000)
Kategorie F Anteile und zehntausend (10.000) Kategorie G Anteile mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1,-), zu
reduzieren und einen Rückkaufpreis von EUR 1.708.594,74 an die Alleingesellschafterin der Gesellschaft zu zahlen.

2. Abänderung des Artikels 5 Absatz 1 der Satzung der Gesellschaft, um den nach dem vorstehenden Punkt 1 zu

fassenden Beschluss widerzuspiegeln.

3. Abänderung des Gesellschafterregisters der Gesellschaft, um die obengenannten Änderungen widerzuspiegeln, mit

Erteilung von Vollmacht an jeden Geschäftsführer, jeder individuell, im Namen und Auftrag der Gesellschaft die Eintragung
des Rückkaufs der Anteile im Gesellschafterregister der Gesellschaft vorzunehmen.

4. Verschiedenes.
Die erschienene Partei, vertreten wie oben erwähnt, hat in ihrer Eigenschaft als Alleingesellschafterin der Gesellschaft

den unterzeichnenden Notar gebeten, folgende Beschlüsse schriftlich festzuhalten:

<i>Erster Beschluss

Die Alleingesellschafterin beschloss, das gezeichnete und eingezahlte Stammkapital der Gesellschaft um einen Betrag

von zehntausend Euro (EUR 10.000,-) durch Rückkauf und Annullierung von sämtlichen zehntausend (10.000) Kategorie
H Anteilen mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1,-) gemäß der Satzung der Gesellschaft herabzusetzen, um
somit das Stammkapital der Gesellschaft von seinem gegenwärtigen Betrag von zweiundneunzigtausendfünfhundert Euro
(EUR 92.500,-), unterteilt in zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteile, zehntausend (10.000) Kategorie A Anteile,
zehntausend (10.000) Kategorie B Anteile, zehntausend (10.000) Kategorie C Anteile, zehntausend (10.000) Kategorie
D Anteile, zehntausend (10.000) Kategorie E Anteile, zehntausend (10.000) Kategorie F Anteile, zehntausend (10.000)
Kategorie G Anteile und zehntausend (10.000) Kategorie H Anteile mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1,-),
auf zweiundachtzigtausendfünfhundert Euro (EUR 82.500,-), unterteilt in zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteile,
zehntausend (10.000) Kategorie A Anteile, zehntausend (10.000) Kategorie B Anteile, zehntausend (10.000) Kategorie C
Anteile,  zehntausend  (10.000) Kategorie  D Anteile,  zehntausend (10.000) Kategorie E  Anteile,  zehntausend  (10.000)
Kategorie F Anteile und zehntausend (10.000) Kategorie G Anteile mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1,-), zu
reduzieren und einen Rückkaufpreis von EUR 1.708.594,74 an die Alleingesellschafterin der Gesellschaft zu zahlen.

<i>Zweiter Beschluss

Die Alleingesellschafterin beschloss, Artikel 5 Absatz 1 der Satzung der Gesellschaft abzuändern, der nun wie folgt

lautet:

"Das  Stammkapital  der  Gesellschaft  beträgt  zweiundachtzigtausendfünfhundert  Euro  (EUR  82.500,-),  unterteilt  in

zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteile, zehntausend (10.000) Kategorie A Anteile, zehntausend (10.000) Kate-
gorie  B  Anteile,  zehntausend  (10.000)  Kategorie  C  Anteile,  zehntausend  (10.000)  Kategorie  D  Anteile,  zehntausend
(10.000) Kategorie E Anteile, zehntausend (10.000) Kategorie F Anteile und zehntausend (10.000) Kategorie G Anteile
mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1,-)."

<i>Dritter Beschluss

Die Alleingesellschafterin beschloss, das Gesellschafterregister der Gesellschaft abzuändern, um die obengenannten

Änderungen widerzuspiegeln, und bevollmächtigt jeden Geschäftsführer, jeder individuell, im Namen und Auftrag der
Gesellschaft die Eintragung des Rückkaufs der Anteile im Gesellschafterregister vorzunehmen.

157743

L

U X E M B O U R G

<i>Erklärung

Hierüber wurde die vorliegende Urkunde in Luxemburg aufgesetzt, am Tag wie eingangs dieser Urkunde erwähnt.
Der unterzeichnete Notar, der die Englisch versteht und spricht, bestätigt hiermit, dass auf Antrag der erschienenen

Partei diese notarielle Urkunde in Englisch verfasst wurde, mit einer deutschen Übersetzung im Anschluss, und dass im
Falle einer Diskrepanz zwischen dem englischen und dem deutschen Text der englische Text maßgebend ist.

Nach Vorlesung der Urkunde gegenüber dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei, die dem Notar nach Namen,

Vornamen, Personenstand und Wohnort bekannt ist, hat dieselbe zusammen mit dem Notar diese Originalurkunde un-
terschrieben..

Signé: Henryon, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 29 septembre 2014. Relation: EAC/2014/13052. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur ff.

 (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2014156177/165.
(140176498) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2014.

NW Europe Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 137.500,00.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 160.476.

In the year two thousand fourteen, on the thirstiest day of July.
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

1) NW Europe (No.2) Limited Partnership, a limited partnership organized and existing under the laws of England and

Wales pursuant to the Limited Partnerships Act 1907 with registered number LP014408, acting by its general partner,
Northwood  Canada  AIV  GP  Limited  Partnership,  an  Alberta  Limited  Partnership,  itself  acting  by  its  general  partner
Northwood Canada AIV GP LLC, a Delaware limited liability company, having its registered office at c/o The Corporation
Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801,
United States, duly represented by Gersende Masfayon, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a
proxy given under private seal.

2) NW Europe Co-Invest (No.2) Limited Partnership, a limited partnership organized and existing under the laws of

England and Wales pursuant to the Limited Partnerships Act 1907 with registered number LP014410, acting by its general
partner, Northwood Canada AIV GP Limited Partnership, an Alberta Limited Partnership, itself acting by its general
partner Northwood Canada AIV GP LLC, a Delaware limited liability company, having its registered office at c/o The
Corporation Trust Company, Corporation Trust Center,1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Dela-
ware 19801, United States, duly represented by Gersende Masfayon, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by
virtue of a proxy given under private seal.

3) Northwood Employees LP, a limited partnership, incorporated and existing under the laws of the State of Delaware,

having its registered office at c/o Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, City of Wilmington,
County of New Castle 19808, USA, itself represented by its general partner Northwood GP LLC, duly represented by
Gersende Masfayon, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

4) NW Europe Employees Co-Invest Limited Partnership, a limited partnership, incorporated and existing under the

laws of England and Wales pursuant to the Limited Partnership Act 1907, under registration number LP 14417, acting by
its general partner, Northwood Canada AIV GP Limited Partnership, an Alberta Limited Partnership, itself acting by its
general partner Northwood Canada AIV GP LLC, a Delaware limited liability company, having its registered office at c/
o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County,
Delaware 19801, United States, duly represented by Gersende Masfayon, lawyer, professionally residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal.

The proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned

notary, shall remain attached to this deed in order to be registered therewith.

Such appearing parties are the shareholders (the "Shareholders") of NW Europe Holdings S.à r.l., a société à respon-

sabilité  limitée  incorporated  and  existing  under  the  laws  of  the  Grand  Duchy  of  Luxembourg,  registered  with  the
Luxembourg trade and companies' register under number B 160.476, having its registered office 22, Rue Goethe, L-1637
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated on 20 April 2011 pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger,
notary residing in Luxembourg, published in the Memorial C, Recueil des Societés et Associations number 1523 on 9 July
2011 (the "Company"). The articles of incorporation were amended for the last time on 20 May 2014 pursuant to a deed

157744

L

U X E M B O U R G

of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Memorial C,
Recueil des Sociétés et Associations number 1653 on 27 June 2014.

A. The Shareholders declared and requested the notary to record what follows:
The Shareholders together hold one million two hundred fifty thousand (1,250,000) Class A Shares, one million two

hundred fifty thousand (1,250,000) Class B Shares, one million two hundred fifty thousand (1,250,000) Class C shares,
two million five hundred thousand (2,500,000) Class D Shares, one million two hundred fifty thousand (1,250,000) Class
E Shares, one million two hundred fifty thousand (1,250,000) Class F Shares, one million two hundred fifty thousand
(1,250,000) Class G Shares, one million two hundred fifty thousand (1,250,000) Class H Shares and one million two
hundred fifty thousand (1,250,000) Class I Shares in issue in the Company.

B. The Shareholders, representing the entire share capital of the Company, then declared and requested the under-

signed notary to record the following resolutions taken by unanimous vote of the Shareholders:

<i>First Resolution

The Shareholders resolve to create a new class "J" of shares (the "Class J Shares") within the share capital of the

Company. The Class J Shares shall reflect the Company's investments in NW Templar House Holdco Limited and NW
Templar House Limited and shall as such be entitled to any proceeds derived from such investments. The Class J Shares
shall have specific rights and obligations set out in the Company's articles of association as amended pursuant to the
resolutions here below.

<i>Second Resolution

The Shareholders resolve to increase the share capital of the Company by an amount of twelve thousand five hundred

Euro (EUR 12,500.-) so as to raise it from its present amount of one hundred twenty-five thousand Euro (EUR 125,000.-),
represented by one million two hundred fifty thousand (1,250,000) Class A Shares, one million two hundred fifty thousand
(1,250,000) Class B Shares, one million two hundred fifty thousand (1,250,000) Class C Shares, two million five hundred
thousand (2,500,000) Class D Shares, one million two hundred fifty thousand (1,250,000) Class E Shares, one million two
hundred fifty thousand (1,250,000) Class F Shares, one million two hundred fifty thousand (1,250,000) Class G, one million
two hundred fifty thousand (1,250,000) Class H Shares and one million two hundred fifty thousand (1,250,000) Class I
Shares with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each, up to an amount of one hundred thirty-seven thousand five
hundred Euro (EUR 137,500.-) by the creation and issue of one million two hundred fifty thousand (1,250,000) Class J
Shares, with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each.

<i>Subscription and payment

Thereupon, NW Europe (No.2) Limited Partnership, pre-named, here represented as aforementioned, declares to

subscribe for one million two hundred eighteen thousand five hundred twenty seven (1,218,527) Class J Shares and to
fully pay them up by way of a contribution in cash amounting to twelve thousand one hundred eighty five Euro and twenty-
seven cents (EUR 12,185.27).

Thereupon, Northwood Employees LP, pre-named, here represented as aforementioned, declares to subscribe for

thirty-one thousand four hundred seventy-three (31,473) Class J Shares and to fully pay them up by way of a contribution
in cash amounting to three hundred fourteen Euro and seventy-three cents (EUR 314,73).

The amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) is as now available to the Company as has been

proved to the undersigned notary.

<i>Third Resolution

As a consequence of the above resolutions, the Shareholders resolve to amend article 6 of the Company's articles of

incorporation in the following manner:

Art. 6. The Company's share capital is set at one hundred thirty-seven thousand five hundred Euro (EUR 137,500.-)

represented by one million two hundred fifty thousand (1,250,000) class A shares (the “Class A Shares”), one million two
hundred  fifty  thousand  (1,250,000)  class  B  shares  (the  “Class  B  Shares”),  one  million  two  hundred-fifty  thousand
(1,250,000) class C shares (the "Class C Shares"), two million five hundred thousand (2,500,000) class D shares (the “Class
D Shares”), one million two hundred fifty thousand (1,250,000) class E shares (the “Class E Shares”), one million two
hundred fifty thousand (1,250,000) class F shares (the “Class F Shares”), one million two hundred fifty thousand (1,250,000)
class G shares (the “Class G Shares”), one million two hundred fifty thousand (1,250,000) class H shares (the “Class H
Shares”), one million two hundred fifty thousand (1,250,000) class I shares (the “Class I Shares”) and one million two
hundred fifty thousand (1,250,000) class J shares (the “Class J Shares” and together with the Class A Shares, the Class B
Shares, the Class C Shares, the Class D Shares, the Class E Shares, the Class F Shares, the Class G Shares, the Class H
Shares and the Class I Shares, the "Classes of Shares" and each a "Class of Shares”) with a nominal value of one cent (EUR
0.01) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings. The Company may issue additional

classes of shares. Each Class of Shares shall be exclusively entitled to all proceeds relating to a specific investment.

157745

L

U X E M B O U R G

The Class A Shares shall entitle their holders to all proceeds directly or indirectly relating to NW DP Investment S.à

r.l., such as returns on capital, dividend distributions, loan repayments or interest. The Class B Shares shall entitle their
holders to all proceeds directly or indirectly relating to NW One Warrington S.à r.l. such as returns on capital, dividend
distributions, loan repayments or interest. The Class C Shares shall entitle their holders to all proceeds directly or
indirectly relating to NW Finance Company S.à r.l. and NW G Holding S.à r.l. such as returns on capital, dividend distri-
butions, loan repayments or interest. The Class D Shares shall entitle their holders to all proceeds directly or indirectly
relating to NW S Holdings S.à r.l such as returns on capital, dividend distributions, loan repayments or interest. The Class
E Shares shall entitle their holders to all proceeds directly or indirectly relating to Finsbury Dials such as returns on capital,
dividend distributions, loan repayments or interest. The Class F Shares shall entitle their holders to all proceeds directly
or indirectly relating to NW 90 LA Holdco Limited and NW 90 LA Holdings Limited such as returns on capital, dividend
distributions, loan repayments or interest. The Class G Shares shall entitle their holders to all proceeds directly or
indirectly relating to NW Diagonal Mar B.V such as returns on capital, dividend distributions, loan repayments or interest.
The Class H Shares shall entitle their holders to all proceeds directly or indirectly relating to NW HSQ S.à r.l. such as
returns on capital, dividend distributions, loan repayments or interest. The Class I Shares shall entitle their holders to all
proceeds directly or indirectly relating to NW FSP S.à r.l. such as returns on capital, dividend distributions, loan repay-
ments or interest. The Class J Shares shall entitle their holders to all proceeds directly or indirectly relating to NW
Templar House Holdco Limited and NW Templar House Limited such as returns on capital, dividend distributions, loan
repayments or interest.

Any proceeds unrelated to NW DP Investment S.à r.l., NW One Warrington S.à r.l., NW Finance Company S.à r.l.,

NW G Holding S.à r.l., NW S Holdings S.à r.l, Finsbury Dials, NW 90 LA Holdco Limited, NW 90 LA Holdings Limited,
NW Diagonal Mar B.V., NW HSQ S.à r.l., NW FSP S.à r.l., NW Templar House Holdco Limited or NW Templar House
Limited shall be distributed equally among all shareholders pro rata to the number of shares held by each of them.

In addition to the issued share capital, there may be set up a premium account to which any premium paid on any

Class of Shares in addition to its nominal value is transferred. The premium account shall remain allocated and reserved
to the relevant Class of Shares. The amount of the premium account may be used to provide for the payment of any
shares of the relevant Class of Shares which the Company may repurchase only from the holder(s) of shares of such Class
of Shares, to offset any net realized losses with respect to such Class of Shares, to make distributions to the holder(s) of
such Class of Shares in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve pro rata to the amount of profits
produced by such Class of Shares."

<i>Fourth Resolution

The Shareholders resolve to amend the third paragraph of article 12 of the Company's articles of incorporation in

order to reflect the binding powers in respect of the Company, so that such article 12 shall read as follows:

“ Art. 12. The Company is managed by at least two managers, who need not to be shareholders. They shall be two

classes of managers: «Class A Managers» and «Class B Managers». There shall be at least one Class A Manager and Class
B Manager.

The managers are appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office. They may be

dismissed freely at any time and without specific cause.

The Company will be bound in all circumstances by (i) the joint signature of at least one Class A Manager together

with one Class B Manager or (ii) the joint or sole signature of any person(s) to whom such signatory power may have
been delegated by the board of managers”.

<i>Fifth Resolution

The Shareholders resolve to authorize any manager of the Company, acting with full power of substitution, to record

the resolutions adopted above in an appropriate manner in the Company’s books and accounts.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which fall to be borne by the Company as a result of

the presently stated increase of capital are estimated at approximately EUR 2,500.-

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a French version. On request of the appearing party and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.

This deed having been read to the proxyholder of the appearing parties known to the notary by name, first name, civil

status and residence, this proxyholder signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L’an deux mille quatorze, le trente juillet.
Par devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

157746

L

U X E M B O U R G

ONT COMPARU:

1) NW Europe (No.2) Limited Partnership, une société en commandite organisée et existant sous les lois de l‘Angle-

terre et du Pays de Galles selon la Loi sur les sociétés en commandite de 1907 enregistrée sous le numéro LP014408,
agissant via son associé gérant commandité, Northwood Canada AIV GP Limited Partnership, une société en commandite
d'Aiberta, agissant via son associé gérant commandite Northwood Canada AIV GP LLC, une société à responsabilité
limitée du Delaware, ayant son siège social au c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209
Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, Etats-Unis d'Amérique, ici représentée par Gersende
Masfayon, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.

2) NW Europe Co-Invest (No.2) Limited Partnership, une société en commandite organisée et existant sous les lois

d'Angleterre et du Pays de Galles selon la Loi sur les sociétés en commandite de 1907 enregistrée sous le numéro
LP014410, agissant via son associé gérant commandite, Northwood Canada AIV GP Limited Partnership, une société en
commandite  d'Aiberta,  agissant  via  son  associé  gérant  commandité  Northwood  Canada  AIV  GP  LLC,  une  société  à
responsabilité limitée du Delaware ayant son siège social au c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust
Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, Etats-Unis d'Amériques, ici représentée
par Gersende Masfayon, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.

3) Northwood Employees LP, une société en commandite, constituée et existant sous les lois de l‘Etat du Delaware,

ayant son siège social au c/o Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, City of Wilmington, County
of New Castle 19808, Etats-Unis d'Amérique, agissant via son associé gérant commandité Northwood GP LLC, ici re-
présentée par Gersende Masfayon, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing
privé.

4) NW Europe Employees Co-Invest Limited Partnership, une société en commandite, organisée et existant sous les

lois de I ‘Angleterre et du Pays de Galles selon la Loi sur les sociétés en commandite de 1907 enregistrée sous le numéro
LP 14417, agissant via son associé gérant commandite, Northwood Canada AIV GP Limited Partnership, une société en
commandite  d'Aiberta,  agissant  via  son  associé  gérant  commandité  Northwood  Canada  AIV  GP  LLC,  une  société  à
responsabilité limitée du Delaware, ayant son siège social au c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust
Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, Etats-Unis d'Amérique, ici représentée
par Gersende Masfayon, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.

Les procurations, signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et par le notaire soussigné, resteront

annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de I ‘enregistrement.

Les parties comparantes sont les associés (les «Associés») de NW Europe Holdings S.à r.l., une société à responsabilité

limitée, constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 22, rue Goethe,
L-1637 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 160.476,
constitué en date du 20 avril 2011 suivant un acte passe par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg,
publie au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1523 le 9 juillet 2011 (la «Société»). Les statuts de
la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte passé le 20 mai 2014 par Maître Henri Hellinckx, notaire de
résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
numéro 1653 le 27 juin 2014.

A. Les Associés ont déclaré et requis le notaire instrumentant de prendre acte des résolutions suivantes:
Les Associés ensemble détiennent un million deux cent cinquante mille (1.250.000) Parts Sociales de Classe A, un

million deux cent cinquante mille (1.250.000) Parts Sociales de Classe B, un million deux cent cinquante mille (1.250.000)
Parts Sociales de Classe C, deux millions cinq cent mille (2.500.000) Parts Sociales de Classe D, un million deux cent
cinquante mille (1.250.000) Parts Sociales de Classe E, un million deux cent cinquante mille (1.250.000) Parts Sociales de
Classe F, un million deux cent cinquante mille (1.250.000) Parts Sociales de Classe G, un million deux cent cinquante mille
(1.250.000) Parts Sociales de Classe H et un million deux cent cinquante mille (1.250.000) Parts Sociales de Classe I émises
par la Société, représentant l’intégralité du capital social de la Société.

B. Les Associés, représentant l’intégralité du capital social de la Société, ont ensuite déclaré et requis du notaire

instrumentant d'acter les résolutions suivantes adoptées par un vote unanime des Associés:

<i>Première Résolution

Les Associés décident de créer une nouvelle classe «J» de parts sociales au sein du capital social de la Société (les

«Parts Sociales de Classe J»). Les Parts Sociales de Classe J reflèteront les investissements de la Société dans NW Templar
House Holdco Limited et NW Templar House Limited, et donneront droit à ce titre à tous les produits découlant de
ces investissements. Les Parts Sociales de Classe J auront des droits et des obligations spécifiques exposés dans les statuts
de la Société tels que modifiés par les résolutions ci-dessous.

<i>Deuxième Résolution

Les Associés décident d'augmenter le capital social de la Société d’un montant de douze mille cinq cents Euro (EUR

12.500,-) pour le porter de son montant actuel de cent vingt-cinq mille Euro (EUR 125.000,-), représenté par un million
deux cent cinquante mille (1.250.000) Parts Sociales de Classe A, un million deux cent cinquante mille (1.250.000) Parts
Sociales de Classe B, un million deux cent cinquante mille (1.250.000) Parts Sociales de Classe C, deux millions cinq cent

157747

L

U X E M B O U R G

mille (2.500.000) Parts Sociales de Classe D, un million deux cent cinquante mille (1.250.000) Parts Sociales de Classe E,
un million deux cent cinquante mille (1.250.000) Parts Sociales de Classe F, un million deux cent cinquante mille (1.250.000)
Parts Sociales de Classe G, un million deux cent cinquante mille (1.250.000) Parts Sociales de Classe H et un million deux
cent cinquante mille (1.250.000) Parts Sociales de Classe I, ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01)
chacune, à un montant de cent trente-sept mille cinq cents Euro (EUR 137.500,-) par la création et l’émission d’un million
deux cent cinquante mille (1.250.000) Parts Sociales de Classe J ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR
0,01) chacune.

<i>Souscription et paiement

NW Europe (No.2) Limited Partnership, prénommée, ici représentée comme il est dit, déclare alors souscrire à un

million deux cent dix-huit mille cinq cent vingt-sept (1.218.527) Parts Sociales de Classe J et de les payer entièrement au
moyen d'un apport en numéraire d'un montant total de douze mille cent quatre-vingt-cinq Euros et vingt-sept centimes
(EUR 12.185,27).

Northwood Employees LP, prénommée, ici représentée comme il est dit, déclare alors souscrire à trente et un mille

quatre cent soixante-treize (31.473) Parts Sociales de Classe J et de les payer entièrement au moyen d'un apport en
numéraire d'un montant total de trois cent quatorze Euros et soixante-treize centimes (EUR 314,73).

Le montant de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) est dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi

qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Troisième Résolution

En conséquence des résolutions ci-dessus, les Associes décident de modifier l’article 6 des statuts de la Société de la

façon suivante:

« Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à cent trente-sept mille cinq cents euros (EUR 137,500-) représenté

par un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales de classe A (les "Parts Sociales de Classe A»), un million
deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales de classe B (les "Parts Sociales de Classe B»), un million deux cent
cinquante mille (1.250.000) parts sociales de classe C (les "Parts Sociales de Classe C"), deux millions cinq cent mille
(2.500.000) parts sociales de Classe D (les "Parts Sociales de Classe D"), un million deux cent cinquante mille (1.250.000)
parts sociales de Classe E (les "Parts Sociales de Classe E"), un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales
de Classe F (les «Parts Sociales de Classe F»), un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales de Classe
G (les «Parts Sociales de Classe G»), un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales de Classe H (les
«Parts Sociales de Classe H»), un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales de Classe I (les «Parts
Sociales de Classe I») et un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales de Classe J (les «Parts Sociales
de Classe J» et ensemble avec les Parts Sociales de Classe A, les Parts Sociales de Classe B, les Parts Sociales de Classe
C, les Parts Sociales de Classe D, les Parts Sociales de Classe E, les Parts Sociales de Classe F, les Parts Sociales de Classe
G, les Parts Sociales de Classe H et les parts sociales de Classe I, les «Classes de Parts Sociales» et chacune «Classe de
Parts Sociales») d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune.

Chacune des parts sociales donne droit à une voix aux assemblées ordinaires et extraordinaires. La Société peut

émettre des classes de parts sociales additionnelles. Chaque Classe de Parts Sociales donnera exclusivement droit à tous
les produits relatifs à un investissement spécifique.

Les Parts Sociales de Classe A donnent droit à leurs propriétaires aux produits directs ou indirects relatifs à NW DP

Investment S.à r.l., tels que des retours sur capital, des distributions de dividendes, de remboursements d'emprunt ou
d'intérêts. Les Parts Sociales de Classe B donne droit à leurs propriétaires aux produits directs ou indirects relatifs à NW
One Warrington S.à r.l., tels que des retours sur capital, des distributions de dividendes, de remboursements d'emprunt
ou d'intérêts. Les Parts Sociales de Classe C donnent droit à leurs propriétaires aux produits directs ou indirects relatifs
à NW Finance Company S.à r.l. et NW G Holdings S.à r.l., tels que des retours sur capital, des distributions de dividendes,
de remboursements d'emprunt ou d'intérêts. Les Parts Sociales de Classe D donnent droit à leurs propriétaires aux
produits directs ou indirects relatifs à NW S Holding S.à r.l., tels que des retours sur capital, des distributions de divi-
dendes, de remboursements d'emprunt ou d'intérêts. Les Parts Sociales de Classe E donnent droit à leurs propriétaires
aux produits directs ou indirects relatifs à Finsbury Dials, tels que des retours sur capital, des distributions de dividendes,
de remboursements d'emprunt ou d'intérêts. Les Parts Sociales de Classe F donnent droit à leurs propriétaires aux
produits directs ou indirects relatifs à NW 90 LA Holdco Limited et NW 90 LA Holdings Limited, tels que des retours
sur capital, des distributions de dividendes, de remboursements d'emprunt ou d'intérêts. Les Parts Sociales de Classe G
donnent droit à leurs propriétaires aux produits directs ou indirects relatifs à NW Diagonal Mar BV, tels que des retours
sur capital, des distributions de dividendes, de remboursements d'emprunt ou d'intérêts. Les Parts Sociales de Classe H
donnent droit à leurs propriétaires aux produits directs ou indirects relatifs à NW HSQ S.à r.l. tels que des retours sur
capital, des distributions de dividendes, de remboursements d'emprunt ou d'intérêts. Les Parts Sociales de Classe I don-
nent droit à leurs propriétaires aux produits directs ou indirects relatifs à NW FSP S.à r.l. tels que des retours sur capital,
des distributions de dividendes, de remboursements d'emprunt ou d'intérêts. Les Parts Sociales de Classe I donnent droit
à leurs propriétaires aux produits directs ou indirects relatifs à NW FSP S.à r.l. tels que des retours sur capital, des
distributions de dividendes, de remboursements d'emprunt ou d'intérêts. Les Parts Sociales de Classe J donnent droit à

157748

L

U X E M B O U R G

leurs propriétaires aux produits directs ou indirects relatifs à NW Templar House Holdco Limited et NW Templar House
Limited, tels que des retours sur capital, des distributions de dividendes, de remboursements d'emprunt ou d'intérêts.

Les produits n'étant reliés ni à NW DP Investment S.à r.l., NW One Warrington S.à r.l., NW Finance Company S.à

r.l., NW G Holding S.à r.l., NW S Holdings S.à r.l., Finsbury Dials, NW 90 LA Holdco Limited, NW 90 LA Holdings
Limited, NW Diagonal Mar B.V., NW HSQ S.à r.l, NW FSP S.à r.l., NW Templar House Holdco Limited ou NW Templar
House Limited seront distribués de façon équitable parmi tous les associés au prorata du nombre de parts sociales détenu
par chacun d'eux.

En plus du capital social émis, un compte prime d'émission peut être mis en place, auquel toute prime d'émission payée

pour toute Classe de Parts Sociales en plus de sa valeur nominale peut être transférée. Le compte prime d'émission doit
rester alloué et réservé à la Classe de Parts Sociales concernée. Le montant du compte prime d'émission peut être utilisé
pour le paiement des part sociales de la Classe de Parts Sociales concernée que la Société peut racheter seulement au
(x) propriétaire(s) des parts sociales de ladite Classe de Parts Sociales, pour compenser les pertes nettes réalisées en
respect de cette Classe de Parts Sociales, pour faire des distributions au(x) propriétaire(s) de ladite Classe de Parts
Sociales sous la forme de dividendes ou pour allouer des fonds à la réserve légale au prorata du montant des profits
réalisés par ladite Classe de Parts Sociales.»

<i>Quatrième Résolution

Les Associes décident de modifier le paragraphe 3 de l’article 12 des statuts de la Société afin de refléter les pouvoirs

d’engagement en ce qui concerne la Société, de façon à ce que l’article 12 ait la teneur suivante:

« Art. 12. La Société est gérée par au moins deux gérants, qui ne doivent pas nécessairement être associés. Il y aura

deux classes de gérants: «Gérants de Class A» et «Gérants de Class B». Il y aura toujours au minimum un Gérant de
Classe A et un Gérant de Classe B.

Les Gérants sont nommés par l’assemblée générale des associés qui détermine les termes de leurs mandats. Ils peuvent

être révoqués librement à tout moment et sans justification spécifique.

La Société est engagée en toutes circonstances par (i) la signature conjointe d'au moins un Gérant de Classe A et un

Gérant de Classe B ou (ii) la signature conjointe ou la seule signature de toute personne(s) à laquelle un tel pouvoir de
signature aura été délégué par le conseil de gérance».

<i>Cinquième Résolution

Les Associés décident d’autoriser tout gérant de la Société agissant avec les pleins pouvoirs de substitution d’enregistrer

les résolutions adoptées ci-dessus de la façon la plus appropriée dans les livres et comptes de la Société.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

a raison de la présente augmentation de capital, est évalué à environ EUR 2.500,-

DONT ACTE, fait et passe à Luxembourg, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française, sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connue du notaire instrumentant par

son nom, prénom usuel, état et demeure, le mandataire a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: G. MASFAYON et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 5 août 2014. Relation: LAC/2014/37058. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 6 octobre 2014.

Référence de publication: 2014156100/313.
(140176509) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2014.

RW Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 10.050.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 159.189.

In the year two thousand and fourteen, on the thirtieth of September.
Before Maître Jean SECKLER, notary public residing at Junglister, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held

157749

L

U X E M B O U R G

an Extraordinary General Meeting of the sole partner of "RW Holdings S.à r.l." (hereafter referred to as the “Com-

pany”),  a  “Société  à  responsabilité  limitée”,  established  at  5,  rue  Guillaume  Kroll  in  L-1882  Luxembourg,  R.C.S.
Luxembourg section B number 159 189, incorporated pursuant to a deed of the notary Edouard Delosch, on 03 

rd

February 2011, published in the Luxembourg Memorial C number 1070 on 20 

th

 May 2011

There appeared

GLOBANT S.A., a (Société Anonyme) with registered office at 5 rue Guillaume Kroll L-1882 Luxembourg, registered

with  the  Trade  and  Companies  Register  of  Luxembourg  under  the  number  B  173  727  (the  “Sole  Partner”),  hereby
represented by Mr Max MAYER, employee, residing professionally in Luxembourg, 3, route de Luxembourg, Grand-Duchy
of Luxembourg, by virtue of a proxy delivered to him, which proxy, after having been signed ne varietur by the proxy-
holders acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to
be filed with such deed with the registration authorities.

The Sole Partner has declared and requested the undersigned notary to record the following:
I. that the Sole Partner holds all the shares in the share capital of the Company;
II. That the agenda of the present Extraordinary General Meeting is the following:
1. Dissolution of the Company and decision to voluntarily put the Company into liquidation (voluntary liquidation),
2. Appointment of Alter Domus Liquidation Services S. à r.l., a Luxembourg private limited liability company with

registered office at 5, rue Guillaume Kroll in L-1882 Luxembourg as liquidator (the “Liquidator”);

3. Determination of the powers of the Liquidator and the liquidation procedure of the Company;
4. Approval of the management accounts of the Company for the period from 1 

st

 January 2014 to September 30,

2014;

5. Discharge of the managers of the Company for the accomplishment of their respective mandates; and
6. Miscellaneous.
III. The Sole Partner passes the following resolutions:

<i>First resolution:

The Sole Partner resolves to dissolve the Company and to voluntarily put the Company into liquidation (voluntary

liquidation).

<i>Second resolution:

The Sole Partner resolves to appoint Alter Domus Liquidation Services S.à r.l., prenamed, as liquidator (the “Liquida-

tor”).

<i>Third resolution:

The Sole Partner resolves to confer to the Liquidator the powers set forth in articles 144 et seq. of the amended

Luxembourg law on Commercial Companies dated 10 August 1915 (the “Law”).

The Sole Partner further resolves that the Liquidator shall be entitled to pass all deeds and carry out all operations,

including those referred to in article 145 of the Law, without the prior authorisation of the Sole Partner. The Liquidator
may, under its sole responsibility, delegate its powers for specific defined operations or tasks, to one or several persons
or entities.

The Sole Partner further resolves to empower and authorise the Liquidator, acting individually under its sole signature

on behalf of the Company in liquidation, to execute, deliver and perform under any agreement or document which is
required for the liquidation of the Company and the disposal of its assets.

The Sole Partner further resolves to empower and authorise the Liquidator to make, in its sole discretion, advance

payments of the liquidation proceeds to the Sole Partner of the Company, in accordance with article 148 of the Law.

<i>Fourth resolution:

The Sole Partner resolves to approve the management accounts of the Company for the period from 1 

st

 January 2014

to September 30, 2014.

<i>Fifth resolution:

The Sole Partner decides to grant full and total discharge to the board of managers for the accomplishment of their

respective mandates until today.

There being no further business on the Agenda, the meeting was thereupon closed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.

157750

L

U X E M B O U R G

The document having been read to the person appearing, whom is known to the notary by his surname, Christian

name, civil status and residence, the said person signed this original deed with us, the notary.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le trente septembre.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit

l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’associé unique de la société à responsabilité limitée "RW Holdings S.à r.l." (la

“Société”), ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 159 189, constituée suivant acte reçu par le notaire Maître Edouard
Delosch en date du 3 janvier 2011, publié au Mémorial C numéro 1070 du 20 mai 2011.

A comparu

GLOBANT S.A., (Société Anonyme) avec siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, enregistrée

auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 173 727 (l’Associé Unique),

ici représentée par M. Max MAYER, employé, ayant son domicile professionnel à Junglinster, 3, route de Luxembourg,

Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration lui délivrée, laquelle procuration, après signature ne varietur
par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être soumise
avec lui aux formalités de l’enregistrement.

L'Associé Unique a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
I. que l’Associé Unique détient toutes les parts sociales du capital de la Société;
II. l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. Dissolution de la Société et décision de mettre volontairement la Société en liquidation (liquidation volontaire);
2. Nomination de Alter Domus Liquidation Services S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois

ayant son siège au 5, rue Guillaume Kroll à L-1882 Luxembourg, en tant que liquidateur (le “Liquidateur”);

3. Détermination des pouvoirs du Liquidateur et de la procédure de liquidation de la Société;
4. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes de la Société pour la période du 1 

er

 janvier 2014 au 30

septembre 2014;

5. Décharge aux gérants de la Société pour l’accomplissement de leurs mandats respectifs;
6. Divers.
L'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution:

L'Associé Unique décide de dissoudre la Société et de mettre volontairement la Société en liquidation (liquidation

volontaire).

<i>Deuxième résolution:

L'Associé Unique décide de nommer Alter Domus Liquidation Services S.à r.l., précitée, en tant que liquidateur (le

“Liquidateur”).

<i>Troisième résolution:

L'Associé Unique décide d'attribuer au Liquidateur tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi du

10 août 1915 sur les Sociétés Commerciales, telle que modifiée (la “Loi”).

L'Associé Unique décide en outre que le Liquidateur est autorisé à passer tous actes et à exécuter toutes opérations,

en ce compris les actes prévus aux articles 145 de la Loi, sans autorisation préalable de l’Associé Unique. Le Liquidateur
pourra déléguer, sous sa propre responsabilité, ses pouvoirs, pour des opérations ou tâches spécialement déterminées,
à une ou plusieurs personnes physiques ou morales.

L'Associé Unique décide en outre de conférer à et d'autoriser le Liquidateur, agissant individuellement par sa seule

signature au nom de la Société en liquidation, à exécuter, délivrer et réaliser tout contrat ou document requis pour la
liquidation de la Société et la disposition de ses actifs.

L'Associé Unique décide également de conférer à et d'autoriser le Liquidateur, à sa seule discrétion, à verser des

avances sur le solde de liquidation à l’Associé Unique de la Société conformément à l’article 148 de la Loi.

<i>Quatrième résolution:

L'Associé Unique décide d’approuver le bilan et le compte des profits et pertes de la Société pour la période s’écoulant

du 1 

er

 janvier 2014 au 30 septembre 2014.

157751

L

U X E M B O U R G

<i>Cinquième résolution:

L'Associé Unique décide d’accorder pleine et entière décharge aux gérants pour l’exercice de leur mandat jusqu'à ce

jour.

Plus rien n'étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande du comparant le présent acte

est en langue anglaise, suivi d'une version française.

A la demande du comparant et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

Dont Acte, fait et passé à Junglinster, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec

Nous notaire la présente minute.

Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 03 octobre 2014. Relation GRE/2014/3884. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2014156178/126.
(140176757) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2014.

Polyusus Lux IV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 128.312.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 183.037.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-fifth of September,
Before Maître Francis KESSELER, notary residing in Esch-sur-Alzette (Grand Duchy of Luxembourg),

THERE APPEARED:

CAPVIS CO-INVESTORS FASTER GP LIMITED, a limited liability company incorporated and existing under the laws

of Jersey, having its registered office at 28, New Street, JE - JE2 3TE, St. Helier, Jersey and registered with the Jersey
Financial Services Commission Companies Registry under number 116559 acting in its capacity as general partner of
CAPVIS IV CO-INVESTORS FASTER L.P., a limited partnership, established and existing under the laws of Jersey, having
its office address at 28, New Street, JE - JE2 3TE, St. Helier, Jersey and registered with the Jersey Financial Services
Commission Companies Registry under number 1847,

represented by Aïcha CISSE, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given on 25 September

2014.

Said power of attorney after having been signed ne varietur by the representative of the appearing party and the

undersigned notary shall remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Who declared and requested the undersigned notary to record that:
I.- The appearing party, prenamed, represented as stated above, is the sole shareholder of POLYUSUS LUX IV S.à r.l.,

a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) having its registered office at 12F, rue
Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, incorporated by a deed of Me Joseph WAGNER, notary residing in Sanem on 16
December 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 436 of 18 February 2014 and
registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 183037 (the “Company”).

II.- The current issued share capital of the Company is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) divided

into one hundred and twenty-five thousand (125,000) Class A Shares, one hundred and twenty-five thousand (125,000)
Class B Shares, one hundred and twenty-five thousand (125,000) Class C Shares, one hundred and twenty-five thousand
(125,000) Class D Shares, one hundred and twenty-five thousand (125,000) Class E Shares, one hundred and twenty-five
thousand (125,000) Class F Shares, one hundred and twenty-five thousand (125,000) Class G Shares, one hundred and
twenty-five thousand (125,000) Class H Shares, one hundred and twenty-five thousand (125,000) Class I Shares and one
hundred and twenty-five thousand (125,000) Class J Shares with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each (the “Existing
Shares”).

III.- After this had been set forth, the above named sole shareholder representing the entire corporate capital of the

Company, has decided to take the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder decides to convert the one million two hundred and fifty thousand (1,250,000) Existing Shares

into one million two hundred and fifty thousand (1,250,000) ordinary shares (the “Initial Ordinary Shares”) with a nominal
value of one Cent (EUR 0.01) each.

157752

L

U X E M B O U R G

<i>Second resolution

The sole shareholder resolves to create seven (7) new classes of shares of the Company, which shall be designated as

class A1 ordinary shares, class A2 ordinary shares, class A3 ordinary shares, class A4 ordinary shares, class A5 ordinary
shares, class P1 preference shares and class P2 preference shares, each share having a nominal value of one Cent (EUR
0.01).

The sole shareholder resolves that the financial rights attached to the new classes of shares and the conditions of their

repurchase and cancellation will be further determined in the articles of association to be amended as per the following
resolutions.

<i>Third resolution

The sole shareholder decides to increase the corporate capital of the Company by an amount of one hundred and

twenty-eight million three hundred thousand Euro (EUR 128,300,000) so as to raise it from its present amount of twelve
thousand five hundred Euro (EUR 12,500) to one hundred and twenty-eight million three hundred and twelve thousand
five hundred Euro (EUR 128,312,500) by the creation and the issue of four hundred and forty-nine million and fifty
thousand (449,050,000) class A1 ordinary shares, four hundred and forty-nine million and fifty thousand (449,050,000)
class A2 ordinary shares, four hundred and forty-nine million and fifty thousand (449,050,000) class A3 ordinary shares,
four hundred and forty-nine million and fifty thousand (449,050,000) class A4 ordinary shares, four hundred and forty-
nine million and fifty thousand (449,050,000) class A5 ordinary shares, five billion two hundred and ninety-two million
three hundred and seventy-five thousand (5,292,375,000) class P1 preference shares and five billion two hundred and
ninety-two million three hundred and seventy-five thousand (5,292,375,000) class P2 preference shares, each with a
nominal value of one Cent (EUR 0.01).

<i>Subscription and paying up

The four hundred and forty-nine million and fifty thousand (449,050,000) class A1 ordinary shares, four hundred and

forty-nine million and fifty thousand (449,050,000) class A2 ordinary shares, four hundred and forty-nine million and fifty
thousand (449,050,000) class A3 ordinary shares, four hundred and forty-nine million and fifty thousand (449,050,000)
class A4 ordinary shares, four hundred and forty-nine million and fifty thousand (449,050,000) class A5 ordinary shares,
five billion two hundred and ninety-two million three hundred and seventy-five thousand (5,292,375,000) class P1 prefe-
rence shares and five billion two hundred and ninety-two million three hundred and seventy-five thousand (5,292,375,000)
class P2 preference shares with a nominal value of one Cent (EUR 0.01) each, shall be fully paid up, subscribed and allocated
to the sole shareholder by a contribution in cash in the total amount of one hundred and twenty-eight million three
hundred thousand Euro (EUR 128,300,000).

Evidence of the aforementioned contribution in cash has been given to the undersigned notary.

<i>Fourth resolution

The sole shareholder decides to fully restate the articles of association of the Company without amending the cor-

porate object of the Company, which articles will from now on read as follows:

“I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. The name of the company is “POLYUSUS LUX IV S.à r.l.” (the “Company”). The Company is a private

limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in
particular the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the “Law”), and these articles of incorpo-
ration (the “Articles”).

Art. 2. Registered office.
2.1. The Company's registered office is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be

transferred within that municipality by a resolution of the board of managers. It may be transferred to any other location
in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions pre-
scribed for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a

resolution of the board of managers. If the board of managers determines that extraordinary political or military deve-
lopments or events have occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal
activities of the Company at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely
ceased. Any such temporary measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Corporate object.
3.1. The Company's object is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enter-

prises in any form whatsoever, and the management of those participations. The Company may in particular acquire, by
subscription, purchase and exchange or in any other manner, any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and, more generally, any securities and financial instruments

157753

L

U X E M B O U R G

issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. Further, it may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other
intellectual property rights of any nature or origin.

3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. It may lend funds, including, without limitation, the proceeds
of any borrowings, to its subsidiaries and any affiliated companies. It may also give guarantees and pledge, transfer, en-
cumber or otherwise create and grant security over some or all of its assets to guarantee its own obligations and those
of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the avoidance of
doubt, the Company may not carry out any regulated financial sector activities without having obtained the requisite
authorisation.

3.3. The Company may use any legal means and instruments to manage its investments efficiently and protect itself

against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect

to real estate or movable property which, directly or indirectly, favours or relates to its corporate object.

Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period.
4.2. The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy

or any similar event affecting one or more shareholders.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.
5.1. The subscribed capital of the Company is set at one hundred and twenty-eight million three hundred and twelve

thousand five hundred Euro (EUR 128,312,500) divided into:

i) one million two hundred and fifty thousand (1,250,000) initial ordinary shares (the “Initial Ordinary Shares”);
ii) four hundred and forty-nine million and fifty thousand (449,050,000) class A1 ordinary shares (the “Class A1 Or-

dinary Shares”);

iii)  four  hundred  and  forty-nine  million  and  fifty  thousand  (449,050,000)  class  A2  ordinary  shares  (the  “Class  A2

Ordinary Shares”);

iv) four hundred and forty-nine million and fifty thousand (449,050,000) class A3 ordinary shares (the “Class A3 Or-

dinary Shares”);

v) four hundred and forty-nine million and fifty thousand (449,050,000) class A4 ordinary shares (the “Class A4 Or-

dinary Shares”);

vi) four hundred and forty-nine million and fifty thousand (449,050,000) class A4 ordinary shares (the “Class A5 Or-

dinary Shares” and together with the Class A1 Ordinary Shares, the Class A2 Ordinary Shares, the Class A3 Ordinary
Shares, the Class A4 Ordinary Shares, the “Ordinary Shares”);

vii) five billion two hundred and ninety-two million three hundred and seventy-five thousand (5,292,375,000) class P1

preference shares (the “Class P1 Preference Shares”); and

viii) five billion two hundred and ninety-two million three hundred and seventy-five thousand (5,292,375,000) class P2

preference shares (the “Class P2 Preference Shares” and together with the Class P1 Preference Shares, the “Preference
Shares”),

each having a nominal value of one Cent (EUR 0.01).
The Initial Ordinary Shares, the Ordinary Shares and the Preference Shares are hereinafter referred to as the “shares”

and a “share” shall be construed accordingly.

The holders of the shares are together referred to as the “shareholders” and individually a “shareholder”.
5.2.  The  share  capital  may  be  increased  or  reduced  once  or  more  by  a  resolution  of  the  shareholders,  acting  in

accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

5.3. The Company may establish a share premium account (the “Share Premium Account”) into which any premium

paid on any share is to be transferred. Decisions as to the use of the Share Premium Account are to be taken by the
board of managers subject to these Articles. Any amount of share premium paid in addition to the nominal value of any
Ordinary Shares shall be allocated to an available premium reserve which shall be at the free disposal of the Company
and such premium may be distributed or repaid in any manner to the shareholders by decision of the board of managers,
to the extent that the Company has distributable sums within the meaning of the Law and in accordance with the applicable
provisions of the Law. Any amount of share premium paid in addition to the nominal value of any Preference Shares shall
be reserved and attached to the holders of such Preference Shares and shall be distributed or repaid as set out in more
detail in Article 15.3.a), to the extent that the Company has distributable sums within the meaning of the Law and in
accordance with the applicable provisions of the Law.

5.4.  The  Company  may,  without  limitation,  accept  equity  or  other  contributions  without  issuing  shares  or  other

securities in consideration for the contribution and may credit the contributions to one or more accounts. Decisions as

157754

L

U X E M B O U R G

to the use of any such accounts are to be taken by the board of managers subject to the Law and these Articles. For the
avoidance of doubt, any such decision may, but need not, to allocate any amount contributed to the contributor.

5.5. All shares have equal rights subject as otherwise provided in these Articles. Each share is entitled to one vote at

ordinary and extraordinary meetings of the shareholders.

5.6. The share capital of the Company may be reduced through the cancellation of one or more entire classes of

Ordinary Shares and/or Preference Shares through the repurchase and cancellation of all the shares in issue in such class
(es).

5.7. A reduction of share capital of the Company through the repurchase of a class of Ordinary Shares and/or Prefe-

rence Shares may only be made in the following order:

a) First, Class P1 Preference Shares;
b) Second, Class P2 Preference Shares;
For the avoidance of doubt the Ordinary Shares may only be repurchased once the Class P2 Preference Shares have

been repurchased. The repurchase of a class of Ordinary Shares may only be made within the following respective periods
(the "Class Periods"),

c) The period for the Class A1 Ordinary Shares is the period starting on 25 September 2014 and ending no later than

on 31 December 2019 (the "Class A1 Period");

d) The period for the Class A2 Ordinary Shares is the period starting on the day after the Class A1 Period and ending

no later than 31 December 2020 (the "Class A2 Period");

e) The period for the Class A3 Ordinary Shares is the period starting on the day after the Class A2 Period and ending

no later than on 31 December 2021 (the "Class A3 Period”);

f) The period for the Class A4 Ordinary Shares is the period starting on the day after the Class A3 Period and ending

no later than on 31 December 2022 (the "Class A4 Period"); and

g) The period for the Class A5 Ordinary Shares is the period starting on the day after the Class A4 Period and ending

no later than 31 December 2023 (the "Class A5 Period”).

5.8. In the event a class of Ordinary Shares has not been repurchased and cancelled within the relevant Class Period,

the repurchase and cancellation of such class of Ordinary Shares can be made during a new period (the “New Period”)
which shall start on the date after the last Class Period applicable to the Ordinary Shares, respectively (or as the case
may be, the date after the end of the immediately preceding New Period of another class) and end no later than one (1)
year after the start date of such New Period. The first New Period shall start on the day after the Class A5 Period and
the class of Ordinary Shares not repurchased and not cancelled in their respective Class Period shall come in the order
from class A1 to class A5 respectively (to the extent not previously repurchased and cancelled) subject to the limitations
prescribed under Article 15.3.c).

For the avoidance of doubt, in the event that a repurchase and cancellation of a class of Ordinary Shares shall take

place prior to the last day of its respective Class Period (or as the case may be, New Period), the following Class Period
(or as the case may be, New Period shall start on the day after the repurchase and cancellation of such class of Ordinary
Shares and shall continue to end on the last day of its respective Class Period (or as the case may be, New Period).

5.9. In the event of a reduction of share capital through the repurchase and cancellation of a class of Ordinary Shares,

such class of Ordinary Shares gives right to the holders thereof pro rata to their holding in such class to the Available
Amount 2 (with the limitation however to the Total Cancellation Amount) and the holders of the repurchased and
cancelled class of Ordinary Shares shall be entitled to an amount equal to the Cancellation Value Per Share for any
repurchased and cancelled Ordinary Share plus, pro rata to their holding in the Class P2 Preference Shares, in any Catch
Up Amount not yet paid.

In the event of a reduction of share capital through the repurchase and cancellation of a class of Preference Shares,

such class of Preference Shares gives right to the holders thereof pro rata to their holding in such class to the Available
Amount 1 (with the limitation however to the Total Cancellation Amount) and the holders of the repurchased and
cancelled class of Preference Shares shall be entitled to an amount equal to the Cancellation Value Per Share for any
repurchased and cancelled Preference Share.

5.10. The Cancellation Value Per Share shall be calculated by dividing the Total Cancellation Amount by the number

of shares in issue in the class of shares to be repurchased and cancelled. The Total Cancellation Amount shall be an
amount determined by the board of managers on the basis of the relevant Interim Accounts and, in relation to the
Preference Shares, taking into account also the provisions of Article 15.3. below. The Total Cancellation Amount for
each  relevant  class  of  shares  shall  be  the  Available  Amount  of  the  relevant  class  at  the  time  of  the  repurchase  and
cancellation of the relevant class of shares provided however that the Total Cancellation Amount shall never be higher
than the Available Amount of the relevant class of shares. Upon the repurchase and cancellation of the shares of the
relevant class of shares, the Cancellation Value Per Share will become due and payable by the Company.

5.11. For the purposes of these Articles, the following words shall have the following definitions:
“Available Amount 1” means to the extent permitted by the Law, the sum of (i) the amount of share capital reduction

and legal reserve reduction relating to the class of Preference Shares to be cancelled, (ii) any freely distributable reserves
(including for the avoidance of doubt the share premium reserve paid in relation to the class to be repurchased, (iii)

157755

L

U X E M B O U R G

Preferred Dividends (including any Special Preferred Dividend Reserves and Catch Up Amount) relating to the class of
Preference Shares repurchased, and (iv) if applicable, the Catch-Up Amount which had not been paid to the holders of
the classes of the Preference Shares previously redeemed.

"Available Amount 2" means the total amount of net profits attributable to that class of shares (including carried

forward profits of shares) increased by (i) any freely distributable reserves (including for the avoidance of doubt the share
premium reserve in relation to the Ordinary Shares), (ii) as the case may be, by the amount of the share capital reduction
and legal reserve reduction relating to the class of shares to be cancelled to the extent this corresponds to the available
amounts in accordance with the law but reduced by (i) any losses (included carried forward losses) expressed as a positive
and (ii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of the Law or of these Articles or in the
reasonable opinion of the board of managers set aside to cover running costs of the Company, each time as set out in
the relevant Interim Accounts (without for the avoidance of doubt, any double counting), (iii) any dividends to which is
entitled the holder(s) of the Initial Ordinary Shares and Ordinary shares still outstanding pursuant to the Articles and (iv)
by Available Amount 1 so that:

AA2 = (NP+P+ CR) - (L +LR +PR + OD +AA1)
Whereby:
AA2 = Available Amount 2;
NP = net profits (including carried forward profits);
P = freely distributable share premium and reserves;
CR = the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the class of shares to be cancelled

to the extent this corresponds to the available amounts in accordance with the Law;

L = losses (including carried forward losses if any) expressed as a positive;
LR = any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of the Law or of the Articles;
PR = sums set aside to cover running costs of the Company in the reasonable opinion of the board of managers;
OD = any dividends to which is entitled the holder(s) of the Initial Ordinary Shares and Ordinary Shares still outstanding

pursuant to the Articles;

AA1 = Available Amount 1;
"Cancellation Value Per Share” means the cancellation amount per share within the relevant class to be paid to the

shareholders.

"Interim Accounts" means the interim accounts of the Company as at the relevant Interim Account Date.
"Interim Accounts Date" means the date no earlier than eight (8) days before the date of the repurchase and cancel-

lation of the relevant class of shares.

"Total Cancellation Amount" means the amount to be paid as the redemption price for the class of shares so redeemed.

The Available Amount of the relevant class of shares, as the case may be, shall be determined by the board of managers,
in good faith and within the best corporate interest of the Company and always in accordance with the Law. For the
avoidance of doubt, the board of managers may determine at its sole discretion to include or exclude in its determination
of the Available Amount of the relevant class of shares, as the case may be, the share premium paid in either in part or
in totality.

Art. 6. Shares.
6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
6.2. A register of shareholders is kept at the registered office of the Company and may be examined by any shareholder

on request.

6.3. The Company may redeem its own shares, provided it has sufficient distributable reserves for that purpose, or if

the redemption results from a reduction in the Company's share capital.

Art. 7. Transfer of Shares - Restrictions.
7.1. Any disposal, transfer, pledge or encumbrance of shares by a shareholder other than the Majority Shareholder

shall be subject to the prior written approval of the Majority Shareholder.

7.2. The Majority Shareholder may dispose, transfer, pledge or encumber its shares without the prior written approval

of the other shareholders.

7.3. Where the Majority Shareholder wishes to sell all or part of its shares in the Company whereby it no longer

retains Control over the Company (the “Sold Shares”) to a third party buyer (a “Third Party Buyer”) it shall first serve
written notice on the other shareholders (such other shareholders being the “Non-Transferring Shareholders”) specifying
the Third Party Buyer, the number and class of Sold Shares, the price and a summary of the key terms at which it wishes
to sell its Sold Shares to the Third Party Buyer and each of the Non-Transferring Shareholders may within ten (10)
Business Days of the receipt of such notice serve written notice on the Majority Shareholder requiring that the Third
Party Buyer purchases up to such portion of the shares held by it that the percentage of his remaining shares equals the
percentage of shares of the same class still held by the Majority Shareholder out of all shares of such class outstanding at
that time (the “Tag Along Right”). If the Tag Along Right is not exercised, the Majority Shareholder shall be entitled to

157756

L

U X E M B O U R G

sell the Sold Shares upon the terms notified to the Non-Transferring Shareholders. If the sale is not signed within sixty
(60) Business Days of the notification or not signed in line with the terms notified to the Non-Transferring Shareholders,
the Tag Along Right shall apply again if the Majority Shareholder intends to effect a sale.

The Tag Along Right shall not apply:
- in case of a transfer of shares made in connection with a pledge enforcement or an insolvency;
- if the Majority Shareholder exercises the Drag Along Right as defined in paragraph 7.4. of these Articles; and
- in case of a Syndication.
The Majority Shareholder shall procure that in case the total number of shares that can be sold to the Third Party

Buyer is exhausted, the sale by the Majority Shareholder is reduced in order to allow the Non-Transferring Shareholders
to participate in such sale pro-rata.

For the purpose of these Articles:
“Majority Shareholder” shall mean a shareholder owning at least fifty percent (50%) of the shares plus one share in

the share capital of the Company.

“Business Day” shall mean any day (other than a Saturday and Sunday) during which the banks are generally open for

business in Luxembourg.

“Control” shall mean (i) directly or indirectly (through contractual arrangements or powers of attorney) holding or

directing more than 50% of the voting rights in an entity or (ii) the power to direct or cause the direction of the mana-
gement and policies of such entity.

“Syndication” shall mean the transfer by the Majority Shareholder of any of its shares in the Company to:
(i) other funds advised by Capvis Equity Partners AG or its affiliates;
(ii) affiliates of the Majority Shareholder or;
(iii) any third party provided the Majority Shareholder retains Control over the Company.
7.4. If the Majority Shareholder wishes to sell all or part of its shares in the Company to a Third Party Buyer, the

Majority Shareholder, at its sole discretion, may require the Non-Transferring Shareholders to sell all of their shares to
such Third Party Buyer (the “Drag-Along Right”) on the same terms and conditions agreed between such Third Party
Buyer and the Majority Shareholder.

The Majority Shareholder shall be entitled to exercise the Drag-Along Right by sending a written notice to the Non-

Transferring Shareholders within ten (10) Business Days of the conclusion of a binding agreement with the Third Party
Buyer specifying the Third Party Buyer, the price and a summary of the key terms at which it wishes to sell its shares to
the Third Party Buyer.

The Drag-Along Right shall not apply in the case of a Syndication.
7.5. Subject to Article 7.6. any transfer restrictions under this Article 7 should not apply to transfer of shares resulting

from the enforcement of a pledge agreement over such shares granted by (i) all the Company’s shareholders over all the
shares issued by the Company at the time of such granting or (ii) one or several shareholders, provided that such pledge
agreement has been approved by a prior written consent of all the other shareholders.

7.6. Notwithstanding the above paragraphs, transfer of shares inter vivos to third parties is subject to the prior approval

given in general meeting, of shareholders representing at least three quarters (3/4) of the share capital.

A share transfer is only binding on the Company or third parties following notification to or acceptance by the Company

in accordance with article 1690 of the Civil Code.

III. Management - Representation

Art. 8. Appointment and Removal of managers.
8.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which sets

the term of their mandate. By a resolution of the shareholders, the appointed managers can be classified as category A
and category B managers. The managers need not be shareholders.

If several managers are appointed, they constitute the board of managers (the “Board”).
8.2. At least half of the Managers shall be resident in Luxembourg.
8.3. The Majority Shareholder shall have the exclusive right and obligation to nominate candidates for all the positions

on the board of managers at each general meeting of shareholders called for the purpose of electing a person to either
such position.

8.4. In connection with each election of a manager to each such position, the Majority Shareholder shall nominate at

least two (2) persons for election to such position.

8.5. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders.
8.6. The Board will elect from among its members a chairman (the “Chairman”). The Chairman will preside the meetings

of the Board. If the Chairman is not present at a meeting of the Board, the managers present or represented may appoint
any one of their members to act as chairman for the purposes of the meeting. In the case of a tied vote, the Chairman
shall not have a casting vote.

157757

L

U X E M B O U R G

Art. 9. Board of managers.
9.1. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of

the Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's corporate
object.

(ii) The Board may delegate special and limited powers to one or more agents for specific matters.
9.2. Procedure
(i) The Board meets at the request of any manager, at the place indicated in the convening notice, which shall be in

the Grand Duchy of Luxembourg.

(ii) Written notice of any Board meeting is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance, except in

the case of an emergency, whose nature and circumstances are set forth in the notice.

(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and state that they know the agenda

for the meeting. A manager may also waive notice of a meeting, either before or after the meeting. Separate written
notices are not required for meetings which are held at times and places indicated in a schedule previously adopted by
the Board.

(iv) A manager may grant another manager power of attorney in order to be represented at any Board meeting

provided that a Luxembourg resident manager may only appoint another Luxembourg resident manager.

(v) The Board may only validly deliberate and act if a majority of its members are present or represented. Board

resolutions are validly adopted by a majority of the votes by the managers present or represented. Board resolutions are
recorded in minutes signed by the Chairman or by all the managers present or represented.

(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other means

of communication initiated from Luxembourg which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak
to each other. Participation by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held
meeting.

(vii) In case of urgency, circular resolutions signed by all the managers (the “Managers' Circular Resolutions”) are valid

and binding as if passed at a duly convened and held Board meeting, and bear the date of the last signature.

9.3. Representation
(i) The Company is bound towards third parties in all matters by the signature of a manager. In case the shareholders

have resolved to classify the appointed managers as category A and category B managers, the Company is bound towards
third parties in all matters by the joint signature of at least one category A and one category B manager.

(ii) The Company is also bound towards third parties by the signature of any person to whom special powers have

been delegated.

Art. 10. Sole manager.
10.1. If the Company is managed by a sole manager, all references in the Articles to the Board of the managers are to

be read as references to the sole manager, as appropriate.

10.2. The Company is bound towards third parties by the signature of the sole manager.
10.3. The Company is also bound towards third parties by the signature of any person to whom the sole manager has

delegated special powers.

Art. 11. Liability of the managers.
11.1. The managers may not be held personally liable by reason of their mandate for any commitment they have validly

made in the name of the Company, provided those commitments comply with the Articles and the Law.

IV. Shareholder(s)

Art. 12. General meetings of shareholders and Shareholders’ circular resolutions.
12.1. Powers and voting rights
(i) Resolutions of the shareholders are adopted at a general meeting of shareholders (the “General Meeting”) or by

way of circular resolutions (the “Shareholders' Circular Resolutions”).

(ii) When resolutions are to be adopted by way of Shareholders' Circular Resolutions, the text of the resolutions is

sent to all the shareholders, in accordance with the Articles. Shareholders' Circular Resolutions signed by all the share-
holders are valid and binding as if passed at a duly convened and held General Meeting, and bear the date of the last
signature.

(iii) Each Share gives entitlement to one (1) vote.
12.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing on the initiative of any managers or

shareholders representing more than one-half of the share capital.

(ii) Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight (8) days prior to the date of the

meeting, except in the case of an emergency whose nature and circumstances are set forth in the notice.

157758

L

U X E M B O U R G

(iii) General Meetings are held at the time and place specified in the notices.
(iv) If all the shareholders are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the

agenda of the General Meeting, it may be held without prior notice.

(v) A shareholder may grant written power of attorney to another person, shareholder or otherwise, in order to be

represented at any General Meeting.

(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders' Circular Resolutions are passed by

shareholders owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting
or first written consultation, the shareholders are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted
a second time, and the resolutions are adopted at the second General Meeting or by Shareholders' Circular Resolutions
by a majority of the votes cast, irrespective of the proportion of the share capital represented.

(vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-

quarters of the share capital.

(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase in a shareholder's commitment to the Company

require the unanimous consent of the shareholders.

Art. 13. Sole shareholder.
13.1. When the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers granted by

the Law to the General Meeting.

13.2. Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders' Circular Reso-

lutions is to be read as a reference to the sole shareholder or the shareholder's resolutions, as appropriate.

13.3. The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.

V. Annual accounts - Distributions - Supervision

Art. 14. Financial year and Approval of annual accounts.
14.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
14.2. The Board prepares the balance sheet and profit and loss account annually, together with an inventory stating

the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising its commitments and the debts owed by its
manager(s) and shareholders to the Company.

14.3. Any shareholder may inspect the inventory and balance sheet at the registered office.
14.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Share-

holders' Circular Resolutions within six (6) months following the closure of the financial year.

Art. 15. Allocation of profit.
15.1. Five per cent (5%) of the Company's annual net profits are allocated to the reserve required by the Law. This

requirement ceases when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share capital.

15.2. After allocation to the legal reserve, the shareholder(s) shall determine how the remainder of the annual net

profits will be disposed of by allocating the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision, by carrying it
forward to the next following financial year or by distributing it, together with carried forward profits, distributable
reserves or share premium to the shareholder(s) in compliance with Article 15.3.

15.3. The decision to distribute funds and the determination of the amount of such distribution will be taken by the

Shareholders in accordance with the following provisions of this Article 15.3.:

a) The holders of each class of the Preference Shares are entitled to annual preferential dividends (the “Preferred

Dividends”) calculated out of

(i) the share capital originally contributed to such class of Preference Shares, comprising the nominal value of the

relevant Preference Shares and the related share premium (not yet repaid) (the "Preferred Share Amount”) as well as of
(ii) the Preferred Dividends attributable to such class of Preference Shares not distributed in previous years (the "Special
Preferred Dividends Reserve"), at the following annual rate:

- the holders of Class P1 Preference Shares shall be entitled to receive dividend distributions in an amount of nine

point fifty per cent (9.50%) of the Preferred Share Amount and of the Special Preferred Dividends Reserve pertaining to
the Class P1 Preference Shares, then,

- the holders of Class P2 Preference Shares shall be entitled to receive dividend distributions in an amount of ten point

fifty per cent (10.50%) of the Preferred Share Amount and of the Special Preferred Dividends Reserve pertaining to the
Class P2 Preference Shares, then,

To the extent that the Preferred Dividends are not distributed in any year, despite the existence of profits available

for that purpose, the amount of the Preferred Dividends (i) shall be allocated to the Special Preferred Dividends Reserve
of each of the Preference Shares classes and (ii) shall be available for preference distributions to the holders of the
respective Preference Shares at the time of the next distribution of dividends of the Company, subject to the shareholders’
approval in a shareholder's resolution.

157759

L

U X E M B O U R G

If the Preferred Dividends are not distributed in full or have been distributed only in part during one or more particular

years, the entitlement to full annual Preferred Dividends shall continue to accrue until it is completely paid. If and to the
extent that, subsequently, profits are made, the entitlement to a full Preferred Dividend accrues and becomes payable,
putting the holder in a position as if the full Preferred Dividend would have accrued in each year (the "Catch-Up Amount”).

In any case, dividends can only be distributed and shares redeemed following a respective shareholders’ resolution or

board of managers resolution and only to the extent that the Company has distributable sums within the meaning of the
Law and in accordance with the applicable provisions of such law.

b) Secondly, the holders of the Class A1 Ordinary Shares shall be granted a right to receive, pro rata, a dividend

representing zero point twenty-five per cent (0.25%) of the nominal value of the Class A1 Ordinary Shares issued by the
Company. The holders of the Class A2 Ordinary Shares shall be granted a right to receive, pro rata, a dividend representing
zero point thirty per cent (0.30%) of the nominal value of the Class A2 Ordinary Shares issued by the Company. The
holders of Class A3 Ordinary Shares shall be granted a right to receive, pro rata, a dividend representing zero point thirty-
five per cent (0.35%) of the nominal value of the Class A3 Ordinary Shares issued by the Company. The holders of the
Class A4 Ordinary Shares shall be granted a right to receive, pro rata, a dividend representing forty per cent (0.40%) of
the nominal value of the Class A4 Ordinary Shares issued by the Company. The holders of the Class A5 Ordinary Shares
shall be granted a right to receive, pro rata, a dividend representing zero point forty-five per cent (0.45%) of the nominal
value of the Class A5 Ordinary Shares issued by the Company. The holders of the Initial Ordinary Shares shall be granted
a right to receive, pro rata, a dividend representing zero point fifty per cent (0.50%) of the nominal value of the Initial
Ordinary Shares issued by the Company.

For the avoidance of doubt, the payments to be made under (b) are to be made on a pari passu basis between the

holders of the classes of Initial Ordinary Shares and Ordinary Shares.

The remainder of any dividend distribution shall be then allocated pro rata to the Ordinary Shares.
Notwithstanding the preceding provisions, the board of managers is authorized to declare and pay interim dividends

to the shareholder(s) in accordance with the distribution provisions described in the preceding provisions of this Article
15.3. before the end of the financial year and in accordance with the applicable legal provisions.

c) For the avoidance of doubt, the holders of the Initial Ordinary Shares and Ordinary Shares shall be entitled to receive

a dividend or interim dividend, including any repayment of share capital, only if either (i) such dividend or interim dividend
has been approved by a respective shareholders’ resolution with a 75% majority of all holders of Preference Shares or if
(ii) (a) all dividend distributions arising under this Article 15.3. in relation to the Preference Shares have been fully paid
to the holders of the Preference Shares in numerical order (e.g. initially Class P1 Preference Shares); and (b) all the issued
Preference Shares have been redeemed and any share premium contributed in connection with the Preference Shares
has been fully repaid to the holder of the Preference Shares in numerical order (e.g. initially Class P1 Preference Shares).

15.4. The board of managers may decide to pay interim dividends to the shareholder(s) before the end of the financial

year on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood
that (i) the amount to be distributed may not exceed, where applicable, realized profits since the end of the last financial
year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums
to be allocated to a reserve to be established according to the Law or these Articles and that (ii) any such distributed
sums which do not correspond to profits actually earned may be recovered from the relevant shareholder(s).

VI. Dissolution - Liquidation

16.1 The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted with the consent of half

(in number) of the shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders appoint one or
more liquidators who need not be shareholders, to carry out the liquidation, and determine their number, powers and
remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators have full power to realise the Company's
assets and pay its liabilities.

16.2 The surplus after payment of all charges, debts (i.e after full repayment of any outstanding loans), expenses which

are a result of liquidation, will be used to reimburse the contribution made by the shareholders on the shares of the
Company. The final surplus will be distributed to the shareholders in conformity with and so as to achieve on aggregate
basis the same economic result as the distribution rules set forth in Article 15 of these Articles.

VII. General provisions

17.1. Notices and communications may be made or waived, and Managers' and Shareholders' Circular Resolutions may

be evidenced, in writing, by fax, e-mail or any other means of electronic communication.

17.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with

Board meetings may also be granted by a manager, in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed

equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers' Circular Resolutions, the resolutions adopted by the
Board by telephone or video conference or the Shareholders' Circular Resolutions, as the case may be, are affixed to

157760

L

U X E M B O U R G

one original or several counterparts of the same document, all of which taken together constitute one and the same
document.

17.4. All matters not expressly governed by these Articles are determined in accordance with the applicable law and,

subject to any non-waivable provisions of the law, with any agreement entered into by the shareholders from time to
time.”

<i>Expenses

The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed, are estimated at approximately seven thousand Euro.

There being no further business before the meeting, the same was adjourned thereupon.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a German version; on request of the same appearing party and
in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date mentioned at the beginning of this document.
The document having been read to the representative of the appearing party, known to the undersigned notary by

name, Christian name, civil status and residence, the said representative of the appearing party signed together with the
notary the present deed.

Follows the german version

Im Jahre zweitausendvierzehn, am fünfundzwanzigsten September,
vor dem Notar Maître Francis KESSELER, mit notarieller Anschrift in Esch-sur-Alzette (Großherzogtum Luxemburg)

ist erschienen

CAPVIS CO-INVESTORS FASTER GP Limited, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet und bestehend

nach dem Recht von Jersey, mit Gesellschaftsitz in 28, New Street, JE - JE2 3TE, St. Helier, Jersey und eingetragen in dem
Handelsregister der Jersey Finanzdienstleistungskommission unter der Nummer 116559, handelnd in seiner Eigenschaft
als Komplementär der CAPVIS IV CO-INVESTORS FASTER L.P., eine Kommanditgesellschaft, gegründet und bestehend
nach dem Recht von Jersey, mit Gesellschaftsitz in 28, New Street, JE - JE2 3TE, St. Helier, Jersey und eingetragen in dem
Handelsregister der Jersey Finanzdienstleistungskommission unter der Nummer 1847,

vertreten  durch  Aïcha  CISSE,  Anwältin,  wohnhaft  in  Luxemburg,  aufgrund  einer  am  25  September  2014  erteilten

Bevollmächtigung.

Diese Vollmacht wird, nach Zeichnung ne varietur durch die Bevollmächtigte der erschienenen Partei und durch den

unterzeichnenden Notar, der vorliegenden Urkunde beigefügt, die bei der Registrierungsbehörde einzureichen ist.

Der Unterzeichnende erklärt vor dem Notar und erbittet diesen zu beurkunden, dass:
I.- Die vorgenannte erschienene Partei, die wie oben angegeben vertreten wird, ist die einzige Anteilsinhaberin der

POLYUSUS LUX IV S.à r.l., eine luxemburgische Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée)
mit Sitz in 12F, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxemburg, gegründet durch notarielle Urkunde des des Notars Joseph
WAGNER, mit Amtssitz in Sanem, an dem 16. Dezember 2013, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations Nummer 436 des 18. Februars 2014 und eingetragen im luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister
unter der Nummer B 183037 (nachfolgend die „Gesellschaft“).

II.- Das bisher ausgegebene Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist festgesetzt auf zwölftausendfünfhundert Euro (EUR

12.500), unterteilt in einhundertfünfundzwanzigtausend (125.000) Klasse A Anteile; einhundertfünfundzwanzigtausend
(125.000) Klasse B Anteile, einhundertfünfundzwanzigtausend (125.000) Klasse C Anteile, einhundertfünfundzwanzigtau-
send (125.000) Klasse D Anteile, einhundertfünfundzwanzigtausend (125.000) Klasse F Anteile, einhundertfünfundzwan-
zigtausend  (125.000)  Klasse  G  Anteile,  einhundertfünfundzwanzigtausend  (125.000)  Klasse  H  Anteile,  einhundertfün-
fundzwanzigtausend (125.000) Klasse I Anteile und hundertfünfundzwanzigtausend (125.000) Klasse J Anteile, jede zu
einem Nominalwert von einem Cent (EUR 0,01) (die „Bestehenden Anteile “).

III.- Dies vorausgeschickt, hat der oben genannte einzige Anteilsinhaber, der das gesamte Stammkapital der Gesellschaft

repräsentiert, entschieden, folgende Beschlüsse zu fassen:

<i>Erster Beschluss

Der alleinige Anteilsinhaber beschließt, die eine Million zweihundertfünfzigtausend (1.250.000) bestehenden Anteile in

eine Million zweihundertfünfzigtausend (1.250.000) Stammanteile (die “Ursprünglichen Stammanteile“) mit einem Nomi-
nalwert von einem Cent (EUR 0,01) umzuwandeln.

<i>Zweiter Beschluss

Der alleinige Anteilsinhaber beschließt, sieben (7) neue Klassen von Anteile der Gesellschaft zu schaffen, die als Klasse

A1 Stammanteile, Klasse A2 Stammanteile, Klasse A3 Stammanteile, Klasse A4 Stammanteile, Klasse A5 Stammanteile,
Klasse P1 Vorzugsanteile und Klasse P2 Vorzugsanteile, jede mit einem Nominalwert von einem Cent (EUR 0,01) be-
zeichnet werden.

157761

L

U X E M B O U R G

Der einzige Anteilsinhaber beschließt, dass die finanziellen Rechte, die mit den neuen Klassen von Anteilen verbunden

sind und die Bedingungen ihres Rückkaufs und ihrer Löschung, in den nach den folgenden Beschlüssen zu ändernden
Satzungsbestimmungen näher festgesetzt werden.

<i>Dritter Beschluss

Der einzige Anteilsinhaber beschließt, das Stammkapital der Gesellschaft um einen Betrag von einhundertachtund-

zwanzig Millionen dreihunderttausend Euro (EUR 128.300.000) zu erhöhen, sodass es von dem aktuellen Betrag von
zwölftausend fünfhundert Euro (EUR 12.500) auf einhundertachtundzwanzig Millionen dreihundertzwölftausend fünfhun-
dert Euro (EUR 128.312.500) durch die Schaffung und die Ausgabe von vierhundertneunundvierzig Millionen fünfzigtau-
send (449.050.000) Klasse A1 Stammanteile, vierhundertneunundvierzig Millionen fünfzigtausend (449.050.000) Klasse A2
Stammanteile, vierhundertneunundvierzig Millionen fünfzigtausend (449.050.000) Klasse A3 Stammanteile, vierhundert-
neunundvierzig  Millionen  fünfzigtausend  (449.050.000)  Klasse  A4  Stammanteile,  vierhundertneunundvierzig  Millionen
fünfzigtausend (449.050.000) Klasse A5 Stammanteile, fünf Milliarden zweihundertzweiundneunzig Millionen dreihundert-
fünfundsiebzigtausend (5.292.375.000) Klasse P1 Vorzugsanteile und fünf Milliarden zweihundertzweiundneunzig Millionen
dreihundertfünfundsiebzigtausend (5.292.375.000) Klasse P2 Vorzugsanteile, jeweils mit einem Nominalwert von einem
Cent (EUR 0,01) erhöht wird.

<i>Zeichnungen und Einzahlungen

Die vierhundertneunundvierzig Millionen fünfzigtausend (449.050.000) Klasse A1 Stammanteile, vierhundertneunund-

vierzig Millionen fünfzigtausend (449.050.000) Klasse A2 Stammanteile, vierhundertneunundvierzig Millionen fünfzigtau-
send (449.050.000) Klasse A3 Stammanteile, vierhundertneunundvierzig Millionen fünfzigtausend (449.050.000) Klasse A4
Stammanteile, vierhundertneunundvierzig Millionen fünfzigtausend (449.050.000) Klasse A5 Stammanteile, fünf Milliarden
zweihundertzweiundneunzig Millionen dreihundertfünfundsiebzigtausend (5.292.375.000) Klasse P1 Vorzugsanteile und
fünf Milliarden zweihundertzweiundneunzig Millionen dreihundertfünfundsiebzigtausend (5.292.375.000) Klasse P2 Vor-
zugsanteile, jeweils mit einem Nominalwert von einem Cent (EUR 0,01), sind vollständig einbezahlt und gezeichnet worden
von  dem  einzigen  Anteilsinhaber  durch  eine  Bareinlage  in  der  Gesamthöhe  von  einhundertachtundzwanzig  Millionen
dreihunderttausend Euro (EUR 128.300.000).

Von der vorgenannten Bareinlage ist dem unterzeichnenden Notar ein Nachweis gegeben worden.

<i>Vierter Beschluss

Der einzige Anteilsinhaber beschließt, die Satzung der Gesellschaft vollständig neu zu formulieren, ohne dabei den

Gesellschaftszweck der Gesellschaft zu ändern, die ab jetzt wie folgt lautet:

I. Firma - Gesellschaftssitz - Gesellschaftszweck - Dauer

Art. 1. Firma. Die Firma der Gesellschaft lautet „POLYUSUS LUX IV S.à r.l.“ (die „Gesellschaft“). Die Gesellschaft ist

eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) und unterliegt den Gesetzen des Großher-
zogtums Luxemburg, insbesondere den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in
seiner jeweils geltenden Fassung (das „Gesetz“) und der hier vorliegenden Gesellschaftssatzung (die „Satzung“).

Art. 2. Gesellschaftssitz.
2.1 Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt, im Großherzogtum Luxemburg. Der Sitz der Gesell-

schaft kann durch Beschluss des Geschäftsführungsrats der Gesellschaft an einen anderen Ort innerhalb der Gemeinde
verlegt werden. Der Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter, in Übereinstimmung mit den Bestim-
mungen über die Satzungsänderung, an jeden anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

2.2 Filialen, Zweigniederlassungen und andere Geschäftsräume können im Großherzogtum Luxemburg oder im Aus-

land  durch  einen  Beschluss  der  Gesellschafterversammlung  errichtet  werden.  Wenn  die  Gesellschafterversammlung
feststellt, dass außergewöhnliche politische oder militärische Entwicklungen oder Ereignisse bestehen oder vorauszusehen
sind und dass diese Entwicklungen oder Ereignisse die normale Geschäftstätigkeit der Gesellschaft am Gesellschaftssitz
oder die Verbindung zwischen diesem Gesellschaftssitz und Personen außerhalb behindern können, kann der Gesell-
schaftssitz vorübergehend ins Ausland verlegt werden, bis die fraglichen Entwicklungen oder Ereignisse vollständig beendet
sind. Derartige vorübergehende Maßnahmen haben keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft, die ungeachtet
einer vorübergehenden Verlegung des Gesellschaftssitzes eine in Luxemburg gegründete Gesellschaft bleibt.

Art. 3. Gesellschaftszweck.
3.1. Zweck der Gesellschaft ist die Akquisition von Beteiligungen an in- oder ausländischen Gesellschaften oder Un-

ternehmen jeder Art, sowie die Verwaltung solcher Beteiligungen. Insbesondere darf die Gesellschaft Aktien, Anteile und
andere Wertpapiere, Anleihen, ungesicherte Obligationen, Einlagezertifikate und andere Schuldtitel und im Allgemeinen
jede Art von Sicherheiten und Finanzinstrumente, die von öffentlich- oder privatrechtlichen Rechtsträgern jeder Art
ausgegeben werden, durch Zeichnung, Kauf oder Tausch oder auf andere Weise erwerben. Die Gesellschaft kann sich
an der Gründung, Entwicklung, Verwaltung und Aufsicht einer jeden Gesellschaft oder eines jeden Unternehmens betei-
ligen. Des Weiteren kann sie in den Erwerb und die Verwaltung eines Patentbestandes oder anderer geistiger Eigen-
tumsrechte jeder Art oder jeden Ursprungs investieren.

157762

L

U X E M B O U R G

3.2. Die Gesellschaft kann Darlehen jeglicher Art aufnehmen, ausgenommen im Wege eines öffentlichen Angebots. Sie

kann, jedoch nur durch Privatplatzierungen, Schuldscheine, Anleihen sowie jegliche Art von Schuldtiteln und Dividen-
denpapieren ausgeben. Die Gesellschaft kann Geldmittel, einschließlich und uneingeschränkt die Erträge aus Kreditver-
bindlichkeiten, an ihre Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften verleihen. Des Weiteren kann die Gesellschaft
in Bezug auf ihr gesamtes oder nur einen Teil ihres Vermögens Sicherheiten leisten, verpfänden, übertragen, belasten
oder auf andere Weise Sicherheiten bestellen und gewähren, um ihre eigenen Verbindlichkeiten und solche anderer
Gesellschaften abzusichern und im Allgemeinen zu ihrem eigenen Vorteil und zum Vorteil jeder anderen Gesellschaft
oder Person. Um Unstimmigkeiten auszuschließen, ist die Gesellschaft nicht dazu befugt, ohne die erforderliche Geneh-
migung reglementierte Tätigkeiten in Bezug auf den Finanzsektor auszuüben.

3.3. Die Gesellschaft ist befugt, sich jeglicher Verfahren und Mittel zu bedienen, um ihre Investitionen effizient zu

verwalten und um sich gegen Kredit-, Wechselkurseinwirkungs-, Zinssatz- und andere Risiken abzusichern.

3.4. Die Gesellschaft ist befugt, alle gewerblichen, finanziellen oder industriellen Tätigkeiten und Transaktionen in Bezug

auf Immobilien und bewegliches Vermögen durchzuführen, welche sich mittelbar oder unmittelbar auf den Gesellschafts-
zweck beziehen lassen oder diesen fördern.

Art 4. Dauer.
4.1. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.
4.2.  Die  Gesellschaft  wird  nicht  aufgrund  eines  Todesfalles,  der  Aufhebung  von  Bürgerrechten,  Rechtsunfähigkeit,

Insolvenz, Konkurs oder einem ähnlichen Vorkommnis, welches einen oder mehrere Gesellschafter betrifft, aufgelöst.

II. Kapital - Geschäftsanteile

Art. 5. Kapital.
5.1. Das gezeichnete Vermögen der Gesellschaft ist festgesetzt auf einhundertachtundzwanzig Millionen dreihundert-

zwölftausend fünfhundert Euro (EUR 128.312.500.-), unterteilt in:

i) Eine Million zweihundertfünfzigtausend (1.250.000) ursprüngliche Stammanteile (die „Ursprünglichen Stammanteile“)
ii) Vierhundertneunundvierzigtausend Millionen fünftzigtausend (449.050.000) Klasse A1 Stammanteile (die „Klasse A1

Stammanteile“)

iii) Vierhundertneunundvierzigtausend Millionen fünftzigtausend (449.050.000) Klasse A2 Stammanteile (die „Klasse

A2 Stammanteile“)

iv) Vierhundertneunundvierzigtausend Millionen fünftzigtausend (449.050.000) Klasse A3 Stammanteile (die „Klasse

A3 Stammanteile“)

v) Vierhundertneunundvierzigtausend Millionen fünftzigtausend (449.050.000) Klasse A4 Stammteile (die „Klasse A4

Stammanteile“)

vi) Vierhundertneunundvierzigtausend Millionen fünftzigtausend (449.050.000) Klasse A5 Stammanteile (die „Klasse

A5  Stammanteile“  und  zusammen  mit  den  Klasse  A1  Stammanteilen,  den  Klasse  A2  Stammanteilen,  den  Klasse  A3
Stammanteilen, den Klasse A4 Stammanteilen, die „Stammanteile“)

vii) Fünf Milliarden zweihundertzweiundneunzig Millionen und dreihundertfünfundsiebzigtausend (5.292.375.000) Klas-

se P1 Vorzugsanteile (die „ Klasse P1 Vorzugsanteile“); und

viii) Fünf Milliarden zweihundertzweiundneunzig Millionen und dreihundertfünfundsiebzigtausend (5.292.375.000) Klas-

se P2 Vorzugsanteile (die „Klasse P2 Vorzugsanteile“ und zusammen mit den Klasse P1 Vorzugsanteilen, die „Vorzugs-
anteile“)

mit einem Nominalwert von jeweils einem Cent (EUR 0,01).
Die Ursprünglichen Stammanteile, die Stammanteile und die Vorzugsanteile werden im Folgenden gemeinsam als „An-

teile“ bezeichnet und ein „Anteil“ soll entsprechend ausgelegt werden.

Die Anteilseigner werden gemeinsam und einzeln jeweils als „Gesellschafter“ bezeichnet.
5.2. Das Stammkapital der Gesellschaft kann einmalig oder mehrfach durch Beschluss der Gesellschafter in Überein-

stimmung mit den vorgeschriebenen Bedingungen für Satzungsänderungen erhöht oder vermindert werden.

5.3. Die Gesellschaft kann ein Agio-Konto (das „Agio-Konto“) errichten, auf welchen jede auf einen Anteil bezahlte

Prämie zu übertragen ist. Die Entscheidungen über die Nutzung eines solchen Agio-Kontos müssen von der Gesellschaf-
terversammlung  getroffen  werden  und  unterliegen  dieser  Satzung.  Jeder  zusätzlich  zum  Nominalwert  eines  jeden
Stammanteils gezahlte Agio-Betrag soll einer verfügbaren Agio-Rücklage zugewiesen werden, über welche die Gesellschaft
frei verfügen können soll und eine solche Prämie soll den Gesellschaftern in irgendeiner Art und Weise durch Beschluss
der Gesellschafterversammlung in dem Maße ausgeteilt oder zurückgezahlt werden, dass die Gesellschaft über ausschütt-
bare Beträge im Sinne des Gesetzes und in Übereinstimmungen mit den Regelungen des Gesetzes verfügt. Jeder zusätzlich
zum Nominalwert eines jeden Vorzugsanteils gezahlte Agio-Betrag soll den Inhabern von solchen Vorzugsanteilen vor-
behalten und zugeordnet werden und soll auf die in Artikel 15.3.a) ausführlicher beschriebene Art in dem Maße verteilt
oder zurückgezahlt werden, dass die Gesellschaft über ausschüttbare Beträge im Sinne des Gesetzes und in Überein-
stimmungen mit den Regelungen des Gesetzes verfügt.

157763

L

U X E M B O U R G

5.4. Die Gesellschaft kann, ohne Beschränkung, Eigenkapital oder sonstige Einlagen akzeptieren, ohne Gesellschafts-

anteile oder andere Sicherheiten in Bezug auf die Einlagen auszugeben und kann die Einlagen auf einem oder mehreren
Konten einbuchen. Die Entscheidungen über die Nutzung eines solchen Agio-Kontos müssen von der Gesellschafterver-
sammlung getroffen werden und unterliegen dieser Satzung. Um jedoch jegliche Unklarheit auszuschließen, kann - muss
jedoch nicht - eine solche Entscheidung dem Einlagenerbringer in Bezug auf die eingezahlte Einlage überlassen werden.

5.5.  Jeder  Anteil  hat  die  gleichen  Rechte,  sofern  nicht  in  dieser  Satzung  etwas  anderes  bestimmt  ist.  Jeder  Anteil

berechtigt zu einer Stimme bei ordentlichen oder außerordentlichen Hauptversammlungen der Gesellschafter.

5.6. Das Stammkapital der Gesellschaft kann durch Aufhebung von einer oder mehrerer vollständiger Klassen der

Stammanteile und/oder bei Vorzugsanteilen durch Rückkauf und Aufhebung aller in (einer) solchen Klasse(n) ausgegebe-
nen Anteile reduziert werden.

5.7. Eine Reduzierung des Stammkapitals der Gesellschaft durch den Rückkauf von Stammanteilen und/oder Vorzugs-

anteilen kann nur in der folgenden Reihenfolge stattfinden:

a) Erstens, Klasse P1 Vorzugsanteile;
b) Zweitens, Klasse P2 Vorzugsanteile;
Um jeglichen Zweifeln vorzubeugen, dürfen Stammanteile nur zurückgekauft werden, nachdem die Klasse P2 Vor-

zugsanteile zurückgekauft wurden. Der Rückkauf einer Klasse der Stammanteile darf nur in den folgenden jeweiligen
Zeiträumen erfolgen (die „Klassen - Zeiträume“).

c) Der Zeitraum für die Klasse A1 Stammanteile ist der Zeitraum, welcher am 25 September 2014 beginnt und spä-

testens zum 31. Dezember 2019 endet (der „Klasse A1 - Zeitraum“).

d) Der Zeitraum für die Klasse A2 Stammanteile ist der Zeitraum, welcher am Tag nach dem Ende des Klasse A1 -

Zeitraums beginnt und spätestens zum 31. Dezember 2020 endet (der „Klasse A2 - Zeitraum“).

e) Der Zeitraum für die Klasse A3 Stammanteile ist der Zeitraum, welcher am Tag nach dem Ende des Klasse A2 -

Zeitraums beginnt und spätestens zum 31. Dezember 2021 endet (der „Klasse A3 - Zeitraum“).

f) Der Zeitraum für die Klasse A4 Stammanteile ist der Zeitraum, welcher am Tag nach dem Ende des Klasse A3 -

Zeitraums beginnt und spätestens zum 31. Dezember 2022 endet (der „Klasse A4 - Zeitraum“).

g) Der Zeitraum für die Klasse A5 Stammanteile ist der Zeitraum, welcher am Tag nach dem Ende des Klasse A4 -

Zeitraums beginnt und spätestens zum 31. Dezember 2023 endet (der „Klasse A5 - Zeitraum“).

5.8. Für den Fall, in welchen eine Klasse an Stammanteilen nicht in dem relevanten Klasse - Zeitraum zurückgekauft

und aufgehoben wurden, kann der Rückkauf und die Aufhebung einer solchen Klasse von Stammanteilen innerhalb eines
neuen Zeitraums (der „neue Zeitraum“) stattfinden, der an dem Datum nach dem letzten Klasse - Zeitraum in Bezug auf
die Stammanteile, bzw. (sofern dies der Fall sein sollte, dem Datum nach dem Ende des unmittelbar vorangegangen neuen
Zeitraums einer anderen Klasse) beginnen und spätestens ein (1) Jahr nach dem Beginn eines solchen neuen Zeitraums
enden. Der erste neue Zeitraum soll an dem Datum nach dem Ende des Klasse A5 - Zeitraums beginnen und die Klassen
von nicht in dem entsprechenden jeweiligen Klassen - Zeitraum zurückgekauften und aufgehobenen Stammanteilen sollen
in der entsprechenden Reihenfolge von Klasse A1 bis Klasse A5 (in dem bisher nicht zurückgekauften oder aufgehobenen
Maß) gemäß den in Artikel 15.3.c beschriebenen Beschränkungen folgen.

Um jeglichen Zweifeln vorzubeugen, für den Fall, dass ein Rückkauf und eine Aufhebung einer Klasse von Stammanteilen

vor dem letzten Tag von deren entsprechendem Klasse-Zeitraum erfolgt (oder falls dies der Fall sein sollte, des neuen
Zeitraums), soll der folgende Klasse-Zeitraum (oder falls dies der Fall sein sollte, der neue Zeitraum) am Tag nach dem
Rückkauf und der Aufhebung einer solchen Klasse von Stammanteilen beginnen und bis zum Ende des letztes Tages seines
entsprechenden Klasse-Zeitraums (bzw. neuen Zeitraums) weitergehen.

5.9. Im Falle einer Reduzierung des Stammkapitals durch den Rückkauf und die Aufhebung einer Klasse von Stamm-

anteilen, verleiht diese Klasse von Stammanteilen an deren Inhaber pro rata zu ihrer Inhaberschaft in einer solchen Klasse
das Recht auf den Verfügbaren Betrag 2 (jedoch mit der Beschränkung auf den Gesamtaufhebungsbetrag) und die Inhaber
der zurückgekauften und aufgehobenen Klasse von Stammanteilen sollen für jeden zurückgekauften und aufgehobenen
Stammanteil das Recht auf einen dem Aufhebungswert pro Anteil entsprechenden Betrag haben, und zusätzlich, pro rata
zu ihrer Inhaberschaft in der Klasse P2 Vorzugsanteile, auf jeden noch nicht bezahlten Nachholbetrag.

Im Falle einer Reduzierung des Stammkapitals durch den Rückkauf und die Aufhebung einer Klasse von Vorzugsanteilen,

verleiht diese Klasse von Vorzugsanteilen an deren Inhaber pro rata zu ihrer Inhaberschaft in einer solchen Klasse das
Recht auf den Verfügbaren Betrag 1 (jedoch mit der Beschränkung auf den Gesamtaufhebungsbetrag) und die Inhaber der
zurückgekauften  und  aufgehobenen  Klasse  von  Vorzugsanteilen  sollen  für  jeden  zurückgekauften  und  aufgehobenen
Stammanteil das Recht auf einen dem Aufhebungswert pro Anteil entsprechenden Betrag haben.

5.10. Der Aufhebungswert pro Anteil wird errechnet, indem der Gesamtaufhebungsbetrag durch die Zahl an ausge-

gebenen Anteilen, in der zurückzukaufenden oder aufzuhebenden Klasse von Anteilen, geteilt wird. Der Gesamtaufhe-
bungsbetrag  soll  ein  durch  den  Geschäftsführungsrat,  auf  der  Grundlage  der  entsprechenden  Zwischenkonten,  und
bezüglich der Vorzugsanteile auch die Bestimmungen des untenstehenden Artikels 15.3. berücksichtigend, bestimmter
Betrag  sein.  Der  Gesamtaufhebungsbetrag  für  jede  relevante  Klasse  an  Anteilen  soll  der  verfügbare  Betrag  der  ent-
sprechenden Klasse zum Zeitpunkt des Rückkaufs und der Aufhebung der jeweiligen Klasse an Anteilen sein, dem jedoch
vorausgesetzt, dass der Gesamtaufhebungsbetrag niemals höher ist, als der verfügbare Betrag der maßgeblichen Klasse

157764

L

U X E M B O U R G

von Anteilen ist. Mit dem Rückkauf und der Aufhebung der Anteile der entsprechenden Klasse von Anteilen wird der
Aufhebungswert pro Anteil für die Gesellschaft fällig und zahlbar werden.

5.11. Zum Zwecke dieser Satzung sollen die folgenden Begriffe die folgenden Definitionen haben:
„Verfügbarer Betrag 1“bedeutet in dem nach dem Gesetz erlaubten Ausmaß, die Summe (i) des Betrages aus der

Reduzierung des Gesellschaftsvermögens und der Reduzierung der gesetzlichen Rücklage in Bezug auf die Klasse der
aufzuhebenden Vorzugsanteile, (ii) jede freie ausschüttbaren Rücklagen (einschließlich zur Vermeidung jeglichen Zweifels
die Rücklagen des gezahlten Agio in Bezug auf die Klasse, die zurückgekauft werden sollte, (iii) Vorzugsdividenden (ein-
schließlich jeder Rücklage von Spezial-Vorzugsdividenden und Nachholbetrag) in Bezug auf die Klasse von zurückgekauften
Vorzugsanteilen, und (iv) falls anwendbar, der Nachholbetrag der nicht an die Inhaber der Klassen der Vorzugsanteile,
welche zuvor nicht ausbezahlt wurden, ausbezahlt wurde.

„Verfügbarer Betrag 2“ meint den gesamten Betrag des Netto-Ertrags zurechenbar zu der Klasse von Anteilen (ein-

schließlich des Gewinnvortrags der Anteile) erhöht durch (i) jede freien auscchüttbaren Rücklagen (einschließlich zur
Vermeidung jeglichen Zweifels die Agio-Reserve in Bezug auf die Stammanteile), (ii) gegebenenfalls, durch den Betrag der
Reduzierung des Gesellschaftsvermögens und der Reduzierung der gesetzlichen Rücklagen in Bezug auf die aufzuhebende
Klasse von Anteilen in dem Maß, welcher den verfügbaren Mengen im Einklang mit dem Gesetz entspricht, jedoch ver-
mindert  um  (i)  jeden  als  positiv  ausgedrückten  Verlust(einschließlich  den  Verlustvortrag)  und  (ii)  jede  Summen,  die
aufgrund  von  gesetzlichen  Bestimmungen  oder  aufgrund  dieser  Satzung  in  Rücklage(n)  platziert  werden  sollten  oder
aufgrund der vernünftigen Meinung des Geschäftsführungsrats beiseite gelegt wurden, um laufende Kosten der Gesell-
schaft zu decken, jedes Mal wie in den relevanten Zwischenkonten aufgeführt (ohne um jeden Zweifel zu vermeiden, jedes
doppelt gezählt), (iii) jede Dividenden, welche den/die Inhaber von nach wie vor ausstehenden Ursprünglichen Anteilen
und Stammanteilen aufgrund der Satzung berechtigen und (iv) durch den Verfügbaren Betrag 1 so dass:

AA2 = (NP+P+ CR) - (L +LR +PR + OD +AA1)
Wobei:
AA2 = Verfügbarer Betrag 2;
NP = Netto-Erträge (einschließlich Gewinnvortrag);
P = frei ausschüttbare Agio und Rücklagen;
CR = der Betrag aus der Reduzierung des Gesellschaftsvermögens und der gesetzlichen Rücklagen in Bezug auf die

aufzuhebenden Klassen - Anteile in dem Maß zu welchen er mit dem im Einklang dem Gesetz verfügbaren Beträgen
entspricht;

L = Verluste (einschließlich Verlustvortrag wenn überhaupt) die als positiv ausgedrückt sind;
LR = jede Summen, die aufgrund von gesetzlichen Bestimmungen oder aufgrund dieser Satzung in Rücklage(n) platziert

werden sollten;

PR = Summen, die aufgrund der vernünftigen Meinung des Geschäftsführungsrats beiseite gelegt wurden, um laufende

Kosten der Gesellschaft zu decken;

OD = jede Dividenden, welche den/die Inhaber von nach wie vor ausstehenden ursprünglichen Anteilen und Stamm-

anteilen aufgrund der Satzung berechtigen;

AA1 = Verfügbarer Betrag 1;
„Stornowert pro Anteil“ meint den Aufhebungsbetrag pro Anteil innerhalb der betreffenden Klasse, der an die Ge-

sellschafter ausgezahlt wird.

„Zwischenkonten“ meint die Zwischenkonten der Gesellschaft an dem betreffenden Zwischenkontodatum.
„Zwischenkontodatum“ meint das Datum, das nicht früher als acht (8) Tage vor dem Tag des Rückkaufs und der

Aufhebung des betreffenden Klassen - Anteils.

„Gesamtstornowert“ meint den als Rücknahmepreis zu zahlenden Betrag für so zurückgenommen Klassen - Anteile.

Der Verfügbare Betrag der betreffenden Klassen - Anteile soll, gegebenenfalls, durch den Geschäftsführungsrat unter
Treu und Glauben und im Rahmen des besten Gesellschaftsinteresses und immer im Einklang mit dem Gesetz bestimmt
werden. Um jegliche Zweifel zu vermeiden, kann der Geschäftsführungsrat nach eigenem Ermessen bestimmen, in seine
Bestimmung über den Verfügbaren Betrag der betreffenden Klassen - Anteile, gegebenenfalls, das bezahlte Agio entweder
teilweise oder vollständig miteinzubeziehen oder auszuschließen.

Art. 6. Anteile.
6.1. Die Anteile sind unteilbar und die Gesellschaft lässt nur einen (1) Eigentümer pro Geschäftsanteil zu.
6.2. Am Sitz der Gesellschaft wird ein Gesellschafterregister geführt, welches auf Anfrage eines jeden Gesellschafters

eingesehen werden kann.

6.3. Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen, vorausgesetzt, die Gesellschaft verfügt über ausreichende

ausschüttbare Reserven oder falls der Rückkauf aufgrund einer Herabsenkung des Gesellschaftskapitals beruht.

Art. 7. Übertragung von Anteilen - Beschränkungen.
7.1  Die  Veräußerung,  Übertragung,  Verpfändung  oder  Belastung  von  Anteilen  durch  einen  Gesellschafter  als  den

Mehrheitsgesellschafter bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Mehrheitsgesellschafters.

157765

L

U X E M B O U R G

7.2 Der Mehrheitsgesellschafter darf seine Anteile ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der anderen Gesell-

schafter veräußern, übertragen, verpfänden oder belasten.

7.3 Möchte der Mehrheitsgesellschafter einen Teil oder alle seiner Anteile an der Gesellschaft an einen Dritten als

Käufer (der „Drittkäufer“) verkaufen, so dass er nicht länger die Gesellschaft beherrscht (die „Verkauften Anteile“), so
muss er zunächst die anderen Gesellschafter schriftlich darüber benachrichtigen (diese anderen Gesellschafter sind die
„NichtÜbertragenden Gesellschafter“). Diese Benachrichtigung benennt den Drittkäufer, die Anzahl und die Anteilsklasse
der Verkauften Anteile, den Preis und eine Zusammenfassung der Kernbedingungen, zu denen der Mehrheitsgesellschafter
die Verkauften Anteile an den Drittkäufer zu veräußern wünscht. Jeder der Nicht-Übertragenen Gesellschafter kann
innerhalb von zehn (10) Geschäftstagen nach Zugang einer solchen Mitteilung durch eine schriftliche Mitteilung an den
Mehrheitsgesellschafter verlangen, dass der Drittkäufer bis zu der Anzahl von Anteilen kauft, die der von ihm gehaltenen
Anteilen entspricht, so dass der Prozentsatz seiner verbleibendem Anteile dem Prozentsatz der gleichen Anteilsklasse
entspricht, die der Mehrheitsgesellschafter an allen Anteilen dieser Klasse, die zu dieser Zeit noch ausstehen („Mitnah-
merecht“).

Wird das Mitnahmerecht nicht ausgeübt, darf der Mehrheitsgesellschafter die Verkauften Aktien zu den Bedingungen

verkaufen, die er den Nicht-Übertragenden Gesellschaftern mitgeteilt hat. Wird der Kaufvertrag nicht innerhalb von
sechzig (60) Geschäftstagen unterschrieben, oder wird er nicht im Einklang mit den Bedingungen unterschrieben, die an
die Nicht-Übertragenden Gesellschafter mitgeteilt wurden, ist das Mitnahmerecht wieder anwendbar, wenn der Mehr-
heitsgesellschafter einen Verkauf beabsichtigt.

Das Mitnahmerecht ist in den folgenden Fällen nicht anwendbar:
- In dem Fall, in dem die Übertragung von Anteilen in Verbindung mit einer Durchsetzung von Pfandrechten oder einer

Insolvenz geschieht;

- Wenn der Mehrheitsgesellschafter das Mitverkaufsrecht wie in Abschnitt 7.4 dieser Satzung definiert ausübt; und
- im Fall einer Syndikatsbildung.
Der Mehrheitsgesellschafter hat dafür zu sorgen, dass in dem Fall, in dem die Gesamtzahl der Anteile, die an den

Drittkäufer verkauft werden können, erschöpft ist, der Verkauf durch den Mehrheitsgesellschafter verringert, um den
NichtÜbertragenden Gesellschaftern zu erlauben, an einem solchen Verkauf pro rata teilzuhaben.

Für die Zwecke dieser Satzung:
“Mehrheitsgesellschafter“ ist ein Gesellschafter, der mindestens fünfzig Prozent (50 %) der Anteile plus einen Anteil

der Anteile am Stammkapital der Gesellschaft hält.

“Geschäftstag” ist einen Tag, der kein Samstag oder Sonntag ist, an dem die Banken allgemein für den Geschäftsverkehr

in Luxemburg geöffnet sind.

“Beherrschung” bedeutet, (i) dass direkt oder indirekt (durch vertragliche Vereinbarung oder Vollmacht) mehr als 50

% der Stimmrechte in einer Unternehmung gehalten werden oder über diese bestimmt wird oder (ii) die Macht, direkt
oder indirekt über die Geschäftsführung und Regelwerke einer solchen Unternehmung zu verfügen.

„Syndikatsbildung“ ist die Übertragung seiner Anteile an der Gesellschaft durch den Mehrheitsgesellschafter an:
(i) andere Fonds, die die Capvis Equity Partners AG oder deren Konzerngesellschaften empfehlen;
(ii) Konzerngesellschaften des Mehrheitsgesellschafters oder;
(iii) Dritte
unter der Voraussetzung, dass der Mehrheitsgesellschafter die Beherrschung über die Gesellschaft behält.
7.4 Wünscht der Mehrheitsgesellschafter, alle oder einen Teil seiner Anteile an der Gesellschaft an einen Drittkäufer

zu veräußern, kann der Mehrheitsgesellschafter von den NichtÜbertragenden Gesellschaftern verlangen, dass sie alle ihre
Aktien an einen solchen Drittkäufer zu den gleichen Bedingungen veräußern (das „Mitverkaufsrecht“), die zwischen dem
Drittkäufer und dem Mehrheitsgesellschafter vereinbart wurden.

Der Mehrheitsgesellschafter darf das Mitverkaufsrecht ausüben, indem er innerhalb von zehn (10) Geschäftstagen nach

Abschluss eines verbindlichen Vertrags mit dem Drittkäufer, welcher den Drittkäufer, den Preis und eine Zusammenfas-
sung der Hauptbedingungen enthält, zu denen er seine Anteile an den Drittkäufer verkaufen möchte, eine schriftliche
Mitteilung an die Nicht-Übertragenden Gesellschafter sendet.

Das Mitverkaufsrecht gilt nicht bei einer Syndikatsbildung.
7.5 Vorbehaltlich Artikel 7.6 sind Übertragungsbeschränkungen dieses Artikels 7 nicht auf die Übertragung von Anteilen

anwendbar, die aufgrund der Durchsetzung eines Pfandvertrags erfolgen, der geschlossen wurde von (i) allen Gesell-
schaftern  der  Gesellschaft  über  alle  Anteile,  die  die  Gesellschaft  zum  Zeitpunkt  der  Begründung  des  Pfandrechts
ausgegeben hat oder (ii) einem oder mehreren Gesellschaftern, sofern alle anderen Gesellschafter zuvor schriftlich einem
solchen Pfandvertrag zugestimmt haben.

7.6 Unbeschadet der obigen Absätze bedarf die Übertragung von Anteilen inter vivos an Dritte der vorherigen Zu-

stimmung von Gesellschaftern, die mindestens drei Viertel (3/4) des Stammkapitals halten, in einer Hauptversammlung.

Eine Übertragung von Anteilen ist gegenüber der Gesellschaft oder Dritten erst dann wirksam, wenn sie gemäß Artikel

1690 des luxemburgischen Bürgerlichen Gesetzbuches der Gesellschaft angezeigt oder von ihr anerkannt wurde.

157766

L

U X E M B O U R G

III. Verwaltung - Stellvertretung

Art. 8. Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern.
8.1 Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern verwaltet. Diese werden durch einen Beschluss

der Gesellschafterversammlung bestellt, welcher auch ihre Amtszeit festlegt. Durch Beschluss der Gesellschafterver-
sammlung  können  die  ernannten  Geschäftsführer  in  Kategorie  A  Geschäftsführer  und  Kategorie  B  Geschäftsführer
unterteilt werden. Wenn mehrere Geschäftsführer ernannt sind, bilden sie gemeinsam den Geschäftsführungsrat (der
„Rat“).

8.2 Mindestens die Hälfte der Geschäftsführer muss in Luxemburg ansässig sein.
8.3 Der Mehrheitsgesellschafter hat ausschließlich das Recht und die Verpflichtung, Kandidaten für alle Ämter im Rat

bei einer Hauptversammlung der Gesellschafter zu nominieren, welche zum Zweck der Wahl einer Person in ein Amt
im Rat einberufen wurde.

8.4 Für jede Wahl eines Geschäftsführers in ein jeweiliges Amt im Rat nominiert der Mehrheitsgesellschafter mindes-

tens zwei (2) Personen für die Wahl in ein solches Amt.

8.5 Die Geschäftsführer können zu jedem Zeitpunkt mit oder ohne Grund von der Hauptversammlung abberufen

werden.

8.6 Der Rat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden (der „Vorsitzende“). Der Vorsitzende leitet die Sitz-

ungen des Rats. Ist der Vorsitzende bei einer Sitzung des Rats nicht anwesend, können die anwesenden oder vertretenen
Geschäftsführer ein Mitglied des Rats als Vorsitzenden wählen, der für die jeweilige Sitzung als Vorsitzender handelt. Bei
Stimmengleichheit verfügt der Vorsitzende nicht über ein ausschlaggebendes Stimmrecht.

Art. 9. Geschäftsführungsrat.
9.1. Befugnisse des Geschäftsführungsrates
(i)  Sämtliche  Befugnisse,  welche  nicht  ausdrücklich  per  Gesetz  oder  durch  die  Satzung  dem/den  Gesellschafter(n)

vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Rates, welchem die Befugnisse zustehen, jegliche Handlungen
und Tätigkeiten auszuführen und zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck im Einklang sind.

(ii) Der Rat kann besondere und eingeschränkte Vollmachten für bestimmte Angelegenheiten an einen oder mehrere

Handlungsbevollmächtigte des Rates übertragen.

9.2. Verfahren
(i) Auf Antrag eines jeden Geschäftsführers findet eine Versammlung des Rates statt, an dem in der Ankündigung

genannten Ort, welcher sich im Großherzogtum Luxemburg befindet.

(ii) Eine schriftliche Ankündigung einer jeden Versammlung des Rates geht allen Geschäftsführern spätestens vierund-

zwanzig (24) Stunden vor der Versammlung zu, es sei denn es liegt ein Notfall vor, dessen Art und Umstand sodann in
der Ankündigung darzulegen ist.

(iii) Eine Ankündigung ist nicht erforderlich, wenn alle Mitglieder des Rates bei der Versammlung anwesend oder

vertreten sind und erklären, dass ihnen die Tagesordnung der Versammlung vollständig bekannt ist. Auf eine Ankündigung
kann ein Geschäftsführer zudem entweder vor oder nach der Sitzung freiwillig verzichten. Gesonderte schriftliche An-
kündigungen sind nicht erforderlich, wenn es sich um eine Versammlung handelt, welche örtlich und zeitlich im Voraus
in einem Terminplan angekündigt wurde, welcher durch den Rat verabschiedet wurde.

(iv) Ein Geschäftsführer kann einem anderen Geschäftsführer eine Vollmacht erteilen, um sich bei Versammlung des

Rates vertreten zu lassen; für einen Geschäftsführer, der in Luxemburg ansässig ist, gilt dies jedoch nur dann, wenn er
einen anderen in Luxemburg ansässigen Geschäftsführer als Bevollmächtigten ernennt.

(v) Der Rat ist nur tagungs- und beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die

Beschlüsse des Rates sind wirksam, wenn sie von der Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Ge-
schäftsführer gefasst werden. Die Beschlüsse des Rates werden in Sitzungsprotokollen festgehalten, welche vom Vorsit-
zenden oder von allen bei der Sitzung anwesenden und vertretenen Geschäftsführern unterzeichnet werden.

(vi) Jeder Geschäftsführer kann per Telefon- oder Videokonferenz oder durch jedes andere, vergleichbare Kommu-

nikationsmittel an einer Versammlung des Rates teilnehmen, welches von Luxemburg aus initiiert wurde und es allen
Teilnehmern der Versammlung ermöglicht, einander zu identifizieren, zu hören und miteinander zu kommunizieren. Eine
solche Teilnahme ist einer persönlichen Teilnahme an einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Versammlung
gleichzusetzen.

(vii) Bei Dringlichkeit sind Zirkularbeschlüsse in Textform, welche von allen Geschäftsführern unterzeichnet sind (die

„Zirkularbeschlüsse der Geschäftsführer“), genauso gültig und verbindlich wie ein Beschluss, der in einer ordentlich ein-
berufenen und abgehaltenen Versammlung des Rates gefasst wurde und tragen das Datum der zuletzt hinzugefügten
Unterschrift.

9.3. Vertretung
(i) Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten in allen Angelegenheiten durch die Unterschrift eines Geschäftsführers

gebunden. Falls die Gesellschafter die Geschäftsführer in Kategorie A Geschäftsführer und Kategorie B Geschäftsführer
unterteilt haben, ist die Gesellschaft Dritten gegenüber nur gebunden, wenn ein Kategorie A Geschäftsführer und ein
Kategorie B Geschäftsführer gemeinsam unterzeichnen.

157767

L

U X E M B O U R G

(ii) Die Gesellschaft wird ebenfalls gegenüber Dritten durch die Unterzeichnung der mit Spezialvollmachten ausge-

statteten Personen gebunden

Art. 10. Alleiniger Geschäftsführer.
10.1. Wird die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer verwaltet, ist jede Referenz, welche sich auf den

Geschäftsführungsrat bezieht, soweit möglich, sinngemäß auch auf den einzelnen Geschäftsführer anzuwenden.

10.2. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten durch die Unterschrift des einzelnen Geschäftsführers verpflichtet.
10.3. Die Gesellschaft wird ebenfalls gegenüber Dritten durch die Unterschrift von Personen gebunden, denen der

einzelne Geschäftsführer Spezialvollmachten erteilt hat.

Art. 11. Haftung der Geschäftsführer.
11.1. Die Geschäftsführer sind aufgrund ihres Amtes nicht persönlich haftbar für Verbindlichkeiten, die sie im Namen

der Gesellschaft wirksam eingegangen sind, vorausgesetzt, dass solche Verbindlichkeiten in Übereinstimmung mit den
Bestimmungen der Satzung sowie dem Gesetz stehen.

IV. Gesellschafter

Art. 12. Hauptversammlung und Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter.
12.1. Vollmachten und Stimmrechte
(i) Beschlüsse der Gesellschafter werden in einer Versammlung der Gesellschafter (die „Hauptversammlung“) oder

durch Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter (die „Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter“) gefasst.

(ii) Werden Beschlüsse im Wege der Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter gefasst, so wird der Inhalt der Beschlüsse

gemäß den Bestimmungen der Satzung an alle Gesellschafter übersandt. Die von allen Gesellschaftern unterzeichneten
Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter, welche das Datum der zuletzt hinzugefügten Unterschrift tragen, sind genauso
gültig und verbindlich als wären diese in einer ordentlich einberufenen und abgehaltenen Hauptversammlung gefasst wor-
den.

(iii) Je ein Geschäftsanteil gewährt eine (1) Stimme.
12.2. Ankündigung, Beschlussfähigkeit, Mehrheit der Stimmen und Wahlverfahren
(i) Auf Initiative eines Geschäftsführers oder der Gesellschafter, welche mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals

vertreten, werden die Gesellschafter zur Hauptversammlung einberufen oder schriftlich zur Entscheidung gebeten.

(ii) Eine schriftliche Ankündigung einer jede Hauptversammlung geht allen Gesellschaftern spätestens acht (8) Tage im

Voraus zu, es sei denn es liegt ein Notfall vor, dessen Art und Umstand sodann in der Ankündigung dazulegen ist.

(iii) Die Hauptversammlungen finden an dem in der Ankündigung genannten Ort, zur in der Ankündigung genannten

Zeit statt.

(iv) Die Hauptversammlung kann ohne vorherige Ankündigung abgehalten werden, wenn alle anwesenden oder ver-

tretenen  Gesellschafter  erklären,  dass  ihnen  die  Tagesordnung  bekannt  ist  und  sie  sich  selbst  als  ordnungsgemäß
einberufen betrachten.

(v) Ein Gesellschafter kann einer anderen Person, bei welcher es sich um einen Gesellschafter handeln kann oder nicht,

eine schriftliche Vollmacht erteilen, um von dieser bei der Hauptversammlung vertreten zu werden.

(vi) Die in den Hauptversammlungen oder in Form von Zirkularbeschlüssen der Gesellschafter zu fassenden Beschlüsse

werden von den Gesellschaftern getroffen, welche mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten. Wird eine
solche Mehrheit bei der ersten Hauptversammlung oder dem ersten Beschluss in Textform nicht erreicht, werden die
Gesellschafter per Einschreiben zu einer zweiten Hauptversammlung geladen oder erneut zur schriftlichen Entscheidung
gebeten und die Beschlüsse oder die Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter werden sodann aufgrund der Mehrheit der
abgegebenen Stimmen gefasst, unbeschadet der Quote des vertretenen Gesellschaftskapitals.

(vii) Die Satzung kann mit Zustimmung der Mehrheit der Gesellschafter, welche mindestens drei Viertel des Gesell-

schaftskapitals vertreten, abgeändert werden.

(viii) Jede Änderung der Nationalität der Gesellschaft und jede Erhöhung der Verpflichtungen eines Gesellschafters

gegenüber der Gesellschaft erfordert die einstimmige Zustimmung aller Gesellschafter.

Art. 13. Alleingesellschafter.
13.1. Sofern die Anzahl der Gesellschafter auf einen (1) Gesellschafter reduziert wird, übt dieser alle Befugnisse aus,

welche auch der Hauptversammlung durch das Gesetz verliehen wurden.

13.2. Bezugnahmen auf die Gesellschafter und die Hauptversammlung oder die Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter

innerhalb dieser Satzung gelten entsprechend für den Alleingesellschafter oder die von ihm gefassten Beschlüsse.

13.3. Die von dem Alleingesellschafter gefassten Beschlüsse sind schriftlich zu verfassen.

V. Jahresabschluss - Gewinnverteilung - Aufsicht

Art. 14. Geschäftsjahr und Genehmigung des Jahresabschlusses.
14.1. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten (1) Januar und endet am einunddreißigsten (31) Dezember eines jeden

Jahres.

157768

L

U X E M B O U R G

14.2. Der Rat erstellt jedes Jahr die Bilanz und die Gewinn- und Verlustkonten der Gesellschaft gemeinsam mit einer

Bestandsliste, welche die Aktiva und Passiva der Gesellschaft wiedergibt mit einem Anhang welcher alle Verpflichtungen
der Gesellschaft, die Verbindlichkeiten der/des Geschäftsführer(s) und der Gesellschafter gegenüber der Gesellschaft
zusammenfasst.

14.3. Ein jeder Gesellschafter kann die Bestandsliste und die Bilanz am Sitz der Gesellschaft einsehen.
14.4. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustkonten werden in der jährlichen Hauptversammlung oder im Wege von

Zirkularbeschlüssen der Gesellschafter innerhalb von sechs (6) Monaten nach Beendigung des Geschäftsjahres genehmigt.

Art. 15. Gewinnausschüttung.
15.1. Fünf Prozent (5%) des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft werden der durch das Gesetz vorgeschriebenen

Rücklage zugeführt. Diese Rücklageeinzahlungspflicht besteht nicht mehr, sobald die gesetzliche Rücklage zehn Prozent
(10%) des Stammkapitals der Gesellschaft erreicht hat.

15.2. Nach Zuführung der gesetzlich vorgeschriebenen Rücklage bestimmen die Gesellschafter, wie der verbleibende

Jahresnettogewinn verwendet wird, indem er ganz oder teilweise einer Rücklage oder Rückstellung zugeführt wird, indem
er in das nächste Geschäftsjahr vorgetragen wird oder indem er an die Gesellschafter im Einklang mit Artikel 15.3 aus-
geschüttet wird, zusammen mit dem Gewinnvortrag, ausschüttbaren Reserven oder Agio.

15.3. Die Entscheidung Geldmittel zu verteilen und den Betrag einer solchen Ausschüttung, wird durch die Gesell-

schafter im Einklang mit den folgenden Regelungen dieses Artikel 15.3. getroffen:

a) Die Inhaber einer jeden Klasse von Vorzugsanteilen haben einen Anspruch auf eine jährliche bevorrechtigte Divi-

dende (die „Vorzugsdividende“) zusammengerechnet aus

(i) dem ursprünglich in eine solche Klasse von Vorzugsanteilen eingezahlten Gesellschaftsvermögen, bestehend aus

dem Nominalwert der betreffenden Vorzugsanteile und dem darauf bezogenen Agio (noch nicht zurückgezahlt) (der
„Vorzugsanteilbetrag“) sowie den (ii) einer solchen Klasse von Vorzugsanteilen zurechenbare Vorzugsdividenden, welche
nicht in den vorangegangenen Jahren ausgeschüttet wurden („Spezial Vorzugsdividenden“), in folgender jährlichen Rate:

- die Inhaber von Klasse P1 Vorzugsanteilen sollen einen Anspruch auf Ausschüttung von Dividenden zu einem Betrag

von neun komma fünfzig Prozent (9,50%) des Vorzugsanteilbetrags und der Rücklagen der Spezial Vorzugdividenden in
Bezug auf die Klasse P1 Vorzugsanteile haben, dann,

- die Inhaber von Klasse P2 Vorzugsanteilen sollen einen Anspruch auf Ausschüttung von Dividenden zu einem Betrag

von zehn komma fünfzig Prozent (10,50%) des Vorzugsanteilbetrags und der Rücklagen der Spezial Vorzugdividenden in
Bezug auf die Klasse P2 Vorzugsanteile haben, dann

in dem Maß, dass die Vorzugsdividenden in keinem Jahr ausgeschüttet wurden und trotz der Existenz von zu diesem

Zweck verfügbaren Gewinnen, soll der Betrag der Vorzugsdividenden (i) den Rücklagen der Spezial Vorzugsdividenden
einer jeden Vorzugsanteil - Klasse zugewiesen werden und (ii) soll für bevorrechtigte Ausschüttungen an die Inhaber der
betreffenden Vorzugsanteile zu dem Zeitpunkt der nächsten Ausschüttung von Dividenden der Gesellschaft, welche der
Zustimmung der Gesellschafter in einem Gesellschafterbeschluss unterliegen, zur Verfügung stehen.

Wenn die Vorzugsdividenden nicht vollständig verteilt oder nur teilweise während einem oder mehrerer bestimmter

Jahre ausgeschüttet wurden, soll der Anspruch auf volle jährliche Vorzugsdividenden fortlaufend weiter anwachsen bis er
vollständig ausbezahlt wurde. Falls und in dem Maß dass, nachträglich Gewinne gemacht wurden und der Anspruch auf
volle Vorzugsdividenden wächst und zahlbar wird, versetzt dies den Inhaber in eine Position als wenn die volle Vorzugs-
dividende in jedem Jahr angewachsen wäre (der “Nachholbetrag“).

In jedem Fall, können Dividende nur aufgrund eines darauf bezogenen Gesellschafterbeschlusses oder eines Beschlusses

des Geschäftsführungsrats und nur in dem Maß, dass die Gesellschaft verteilbare Summen im Sinne des Gesetzes und im
Einklang mit den Bestimmungen eines solchen Gesetzes besitzt, verteilt und Anteile zurückgekauft werden.

b) Zweitens, Inhaber von Klasse A1 Stammanteilen sollen mit dem Recht ausgestattet werden, pro rata, eine Dividende,

welche null komma fünfundzwanzig Prozent (0,25%) des Nominalwerts der von der Gesellschaft ausgegebenen Klasse A1
Stammanteile darstellen, zu erhalten. Die Inhaber von Klasse A2 Stammanteilen sollen mit dem Recht ausgestattet werden,
pro rata, eine Dividende, welche null komma dreißig Prozent (0,30%) des Nominalwerts der von der Gesellschaft aus-
gegebenen Klasse A2 Stammanteile darstellen, zu erhalten. Die Inhaber von Klasse A3 Stammanteilen sollen mit dem
Recht ausgestattet werden, pro rata, eine Dividende, welche null komma fünfunddreißig Prozent (0,35%) des Nominal-
werts der von der Gesellschaft ausgegebenen Klasse A3 Stammanteile darstellen, zu erhalten. Die Inhaber von Klasse A4
Stammanteilen sollen mit dem Recht ausgestattet werden, pro rata, eine Dividende, welche null komma vierzig Prozent
(0,40%) des Nominalwerts der von der Gesellschaft ausgegebenen Klasse A4 Stammanteile darstellen, zu erhalten. Die
Inhaber von Klasse A5 Stammanteilen sollen mit dem Recht ausgestattet werden, pro rata, eine Dividende, welche null
komma fünfundvierzig Prozent (0,45%) des Nominalwerts der von der Gesellschaft ausgegebenen Klasse A5 Stammanteile
darstellen, zu erhalten. Die Inhaber von Ursprünglichen Stammanteilen sollen mit dem Recht ausgestattet werden, pro
rata, eine Dividende, welche null komma fünfzig Prozent (0,50%) des Nominalwerts der von der Gesellschaft ausgegebenen
Ursprünglichen Stammanteile darstellen, zu erhalten.

Um jeglichen Zweifel vorzubeugen, werden die Auszahlungen, die unter b) gemacht wurden auf einer pari passu Basis

zwischen den Inhabern der Klasse der ursprünglichen Stammanteile und der Klasse der Stammanteile ausgezahlt.

Der Rest einer jeden Dividendenausschüttung soll dann pro rata auf die Stammanteile verteilt werden.

157769

L

U X E M B O U R G

Ungeachtet der vorstehenden Regelungen, ist der Geschäftsführungsrat befugt zu Zwischendividende festzustellen und

an den/die Gesellschafter im Einklang mit den Regelungen in den vorangegangenen beschriebenen Bestimmungen des
Artikels 15.3. über die Ausschüttung vor Ende des Geschäftsjahres und im Einklang mit den anwendbaren rechtlichen
Bestimmungen auszuzahlen.

c) Um jeglichen Zweifel zu vermeiden, sollen die Inhaber von ursprünglichen Anteilen und Stammanteilen einen An-

spruch erhalten, Dividenden oder Zwischendividenden, einschließlich jeder Rückzahlung des Gesellschaftsvermögens, nur
zu erhalten wenn entweder (i) eine solche Zwischendividende durch den betreffenden Gesellschafterbeschluss mit einer
Mehrheit von 75% aller Inhaber von Vorzugsanteilen oder wenn (ii) (a) alle Dividendenausschüttungen, welche aus Artikel
15.3 in Bezug auf die Vorzugsanteile herrühren vollständig an die Inhaber von Vorzugsanteilen in zahlenmäßiger Reihen-
folge (bspw. zuerst Klasse P1 Vorzugsanteile); ausbezahlt wurden; und (b) alle ausgegebenen Vorzugsanteile zurückgezahlt
wurden und jedes auf die Vorzugsanteile eingezahlte Agio, vollständig an die Inhaber der Vorzugsanteile in zahlenmäßiger
Reihenfolge zurückgezahlt wurde (bspw. zuerst Klasse P1 Vorzugsanteile).

15.4. Der Geschäftsführungsrat kann darüber entscheiden, vor dem Ende des Geschäftsjahres auf Basis einer Feststel-

lung in den Konten, welche aufzeigen, das ausreichende Geldmittel für die Ausschüttung verfügbar sind, Zwischendivid-
enden an den/die Gesellschafter auszuzahlen, wobei davon auszugehen ist, dass (i) der auszuschüttende Betrag, sofern
anwendbar, nicht den realisierten Gewinn seit dem Ende des letzten Geschäftsjahres, erhöht um den Gewinnvortrag und
ausschüttbare Rücklagen, jedoch vermindert um den Verlustvortrag und Summen, die als Rücklagen aufgrund des Gesetzes
oder dieser Satzung zurückgelegt werden sollen, nicht überschreitet und dass (ii) jede solch ausgeschüttete Summe welche
nicht den verdienten Gewinnen entspricht von den betreffenden Gesellschaftern wieder hergestellt werden.

VI. Auflösung - Liquidation

16.1. Die Gesellschaft kann jederzeit durch einen Beschluss der Hälfte (der Anzahl) der Gesellschafter, welche min-

destens drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals vertreten, aufgelöst werden. Die Gesellschafter ernennen einen oder
mehrere Liquidatoren, bei welchen es sich nicht um Gesellschafter handeln muss, zur Durchführung der Auflösung und
bestimmen ihre Anzahl, Befugnisse und Vergütung. Vorbehaltlich anderweitiger Entscheidungen durch die Gesellschafter
haben die Liquidatoren bzw. hat der Liquidator die Befugnis, die Vermögenswerte zu realisieren und die Verbindlichkeiten
der Gesellschaft zu erfüllen.

16.2. Der verbleibende Überschuss nach Zahlung aller Kosten, Schulden (d.h. nach vollständiger Rückzahlung aller

ausstehender Kredite), und Ausgaben aufgrund der Liquidation werden dazu genutzt die durch die Gesellschafter getä-
tigten Einlagen auf die Anteile der Gesellschaft zu erstatten. Der endgültige Überschuss wird an die Gesellschafter in
Übereinstimmung mit und in dem Umfang eine aggregierte Grundlage mit demselben wirtschaftlichen Ergebnis, wie sie
in den Regelungen über die Ausschüttung in Artikel 15 zu dieser Satzung beschrieben sind, zu erreichen, verteilt.

VII. Allgemeine Bestimmungen

17.1. Mitteilungen und Benachrichtigungen können angefertigt oder es kann darauf verzichtet werden und Zirkular-

beschlüsse der Geschäftsführer und Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter können schriftlich, durch Telefax, E-Mail oder
jeder anderen Form von elektronischem Kommunikationsmittel dokumentiert werden.

17.2. Vollmachten können in jeder der oben beschriebenen Weise erteilt werden. Vollmachten im Zusammenhang mit

einer Versammlung des Rates können von einem Geschäftsführer auch in Übereinstimmung mit den vom Rat genehmigten
Bedingungen erteilt werden.

17.3. Unterschriften können handschriftlich oder aber in elektronischer Form geleistet werden, vorausgesetzt diese

erfüllen alle gesetzlichen Erfordernisse zur Anerkennung als handschriftliche Unterschrift. Unterschriften auf Zirkularbe-
schlüssen der Geschäftsführer, Beschlüsse die in einer Telefon- oder Videokonferenz gefasst werden beziehungsweise
Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter müssen auf dem Original abgegeben werden oder auf mehreren Ausfertigungen
desselben Dokuments, welche zusammen ein und dasselbe Dokument bilden.

17.4. Sämtliche nicht ausdrücklich durch die Satzung geregelten Angelegenheiten richten sich nach den entsprechenden

Regelungen des Gesetzes und, vorbehaltlich einer jeden unabdingbaren Regelung des Gesetzes, jeder Vereinbarung, die
die Gesellschafter von Zeit zu Zeit eingehen.

<i>Auslagen

Kosten, Auslagen, Vergütung oder Gebühren in welcher Form auch immer, die der Gesellschaft aufgrund der gegen-

wärtigen Urkunde entstehen, werden auf ungefähr sieben tausend Euro geschätzt.

Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache versteht und spricht, bestätigt hiermit, dass aufgrund des An-

trags der oben erschienenen Partei, die vorliegende Urkunde in Englisch verfasst ist und eine deutsche Fassung hierauf
folgt; auf Antrag der selben erschienenen Partei und im Fall von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deut-
schen Text, soll die englische Fassung maßgebend sein.

Zu Urkunde dessen, wurde die vorliegende Urkunde in Luxemburg erstellt, zu dem benannten Datum zu Beginn dieses

Dokuments.

157770

L

U X E M B O U R G

Das Dokument wurde in Anwesenheit des Vertreters der erschienenen Partei verlesen, vom unterzeichnenden Notars

bekannt mit seinen Namen, Taufname, Familienstand und Wohnsitz und die Urkunde wurde von dem Vertreter der
erschienenen Partei zusammen mit dem Notar unterzeichnet.

Signé: Cisse, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 26 septembre 2014. Relation: EAC/2014/12971. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2014156148/1068.
(140176504) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2014.

Schwartz Rolladen und Fenster GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5610 Mondorf-les-Bains, 2, avenue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 129.059.

AUFLÖSUNG

Im Jahre zwei tausend vierzehn.
Den vierundzwanzigsten September.
Vor dem unterzeichneten Notar Christine DOERNER mit dem Amtswohnsitz in Bettembourg.

Ist erschienen:

Dame Ellen SCHWARTZ, Kauffrau, geborene STADER, geboren am 14. April 1961, wohnhaft in D-66862 Kindsbach,

Industriestrasse 25;

hier vertreten durch Dame Mandy REISER, Angestellte bei der Nouvelle Fiduciaire Reiserbann sari, mit Sitz in L-3321

Berchem, 32A rue Meckenheck;

aufgrund einer Spezialvollmacht unter Privatschrift vom 21. August 2014, welche Vollmacht "ne varietur" von den

Parteien und dem Notar unterzeichnet worden ist und gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigebogen bleibt um mit
derselben formalisiert zu werden;

welche Komparentin, handelnd wie vorerwähnt, erklärt, dass Dame Ellen SCHWARTZ, alleinige Gesellschafterin ist,

der Gesellschaft mit beschränkter Haftung „SCHWARTZ ROLLADEN UND FENSTER GmbH" (Matricule 20072427808),
mit SitzinL-5610 Mondorf-les-Bains, 2 Avenue des Bains;

eingeschrieben im Handelsregister unter Nummer B 129.059;
gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den Notar Henri Hellinckx, im Amtswohnsitz in Luxemburg, am 23.

Mai 2007, veröffentlicht im Memorial C im Jahre 2007, Seite 78.272;

und umgeändert gemäss Akt aufgenommen durch den handelnden Notar am 30. Juli 2010, veröffentlicht im Memorial

im Jahre 2010, Seite 99.122.

mit einem Gesellschaftskapital von ZWÖLF TAUSEND FÜNF HUNDERT EURO (Euro 12.500.-) eingeteilt in FÜNF

UND ZWANZIG (25) Anteile mit einem Nennwert von je FÜNF HUNDERT EURO (Euro 500.-), gezeichnet durch Frau
Ellen SCHWARTZ, vorgenannt.

Die Gesellschafterin beschliesst:
Dass sie die gesamte Aktiva und Passiva der Gesellschaft übernimmt.
Dass die Gesellschaft am heutigen Tage aufgelöst wird.
Dass zum selben Datum die Liquidation erfolgt ist.
Dass infolgedessen die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "SCHWARTZ ROLLADEN UND FENSTER GmbH"

nicht mehr besteht.

Dass die Bücher der Gesellschaft während fünf (5) Jahre bei der Nouvelle Fiduciaire Reiserbann sàrl, mit Sitz in L-3321

Berchem, 32A rue Meckenheck aufbewahrt werden.

WORUEBER URKUNDE, Aufgenommen zu Bettemburg, in der Amtsstube.
Und nach Vorlesung an die Erschienene, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort

bekannt, hat dieselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Signé: Reiser, C. Doerner.
Enregistré à Esch/Alzette A.C. le 29 septembre 2014. Relation: EAC/2014/13007. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur ff. (signé): Halsdorf.

157771

L

U X E M B O U R G

Suit le texte de la procuration annexée:

<i>Vollmacht

Die Unterzeichnende Ellen SCHWARTZ, geboren om 14.04.196l, wohnhaft in D-66862 KINDSBACH, Industriestraße

25,

erteilt hiermit:
Frau Mandy REISER Angestellte bei der Nouvelle Fiduciaire Reiserbann Sàrl mit Sitz in L-3321 BERCHEM, 32A, rue

Meckenheck,

Vollmacht und Gewalt um Sie bei der Generalversammlung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung
SCHWARTZ ROLLADEN GMBH mit Sitz in L-5610 MONDORF-LES-BAINS, 2, avenue des Bains,
zu vertreten mit der Tagesordnung um eine sofortige Auflösung der Gesellschaft ohne Liquidation.
Die Unterzeichnende gibt seinem Vertreter auch noch Vollmacht sämtliche Akten und Protokolle in seinem Namen

zu unterzeichnen, sämtliche Deklarationen zu machen und generell alles zu machen auch was nicht hier ausdrücklich
vorgesehen ist was aber notwendig ist um diese Generalversammlung zu vertreten. Die Unterzeichnende verspricht
hiermit all dieser nachher und gegebenenfalls zu ratifizieren.

Unterschrieben in KINDSBACH am 21 August 2014
Signés: Ellen SCHWARTZ, ...
Enregistré à Esch/Alzette, Actes Civils, le 29 septembre 20214,...EAC/2014/..., Reçu douze euros. 12,00.€

<i>Le Receveur

 (signé): Monique HALSDORF.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Bettembourg, le 1 

er

 octobre 2014.

Christine DOERNER.

Référence de publication: 2014156207/65.
(140176781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2014.

A.F.C. Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Enseigne commerciale: Automotive-Fashion-Consulting Sàrl.

Siège social: L-9946 Binsfeld, 13, rue Béchel.

R.C.S. Luxembourg B 180.511.

L'an deux mille quatorze, le troisième jour du mois d’octobre.
Par devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

- Monsieur Peter THUES, mécanicien-spécialiste automotive, né le 11 novembre 1963 à Oudenaarde (Belgique), de-

meurant à L-9946 Binsfeld, 13, rue Béchel;

-  Madame  Lucia  ROMAGNUOLO,  modéliste-styliste,  née  le  31  mai  1969  à  Leut  (Belgique),  demeurant  à  L-9946

Binsfeld, 13, rue Béchel, ici représentée par Monsieur Peter THUES, prénommée, en vertu d’une procuration donnée
sous seing privé le 26 septembre 2014.

Ladite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être soumise en même temps avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants, présents ou représentés comme mentionné ci-avant, ont exposé au notaire instrumentant et

l’ont requis d'acter ce qui suit:

I.- Les comparants, présents ou représentés comme mentionné ci-avant, sont les seuls associés de la société à res-

ponsabilité limitée «A.F.C. SARL», avec siège social à L-9952 Drinklange, 26, Ëlwenterstrooss, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 180.511, constituée suivant acte reçu par Maître
Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch, en date du 27 septembre 2013, publiée au Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations numéro 2849 du 13 novembre 2013, et dont les statuts (les «Statuts») n’ont pas
encore été modifiés depuis sa constitution (ci-après «la Société»).

II.- Le capital social de la Société est de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cent (100) parts

sociales de cent vingt-cinq euros (EUR 125.-) chacune, toutes les parts sociales étant entièrement souscrites et apparte-
nant aux associés comme suit:

- Monsieur Peter THUES, prénommé,
Quatre-vingt-dix parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90

- Madame Lucia ROMAGNUOLO, prénommé,
Dix parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Total des parts: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

157772

L

U X E M B O U R G

III. Les associés, prénommés, présents ou représentés comme mentionné ci-avant, représentant l’intégralité du capital

social, se sont réuni en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se considèrent comme dûment convoqués et ont
reconnus être pleinement informés des résolutions à prendre sur base de l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour

1. Transfert du siège social de L-9952 Drinklange, 26, Ëlwenterstrooss à L-9946 Binsfeld, 13, rue Béchel;
2. Modification subséquente de l’article 5 des statuts de la Société;
3. Divers.
Après en avoir délibéré, les comparants, présents ou représentés comme mentionné ci-avant, ont pris, à l’unanimité,

les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés décident de transférer le siège social de la Société de L-9952 Drinklange, 26, Ëlwenterstrooss à l’adresse

suivante: L-9946 Binsfeld, 13, rue Béchel.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, les associés décident de modifier en con-

séquence l’article 5 des statuts de la Société pour lui donner à la teneur suivante:

Art. 5. «Le siège de la Société est établi dans la commune de Weiswampach.
Le siège social peut être transféré à l’intérieur de la même commune par simple décision du gérant ou, en cas de

pluralité de gérants, du Conseil de gérance, et en tout endroit du Grand Duché de Luxembourg aux termes d'une décision
prise par assemblée tenue dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.

La Société peut ouvrir des succursales, des filiales ou d’autres bureaux, dans tout autre lieu du Grand-Duché de

Luxembourg, ainsi qu'à l’étranger.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison du

présent acte sont évalués approximativement à mille cent euros (EUR 1.100,-).

DONT ACTE, fait et passé à Weiswampach, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs noms,

prénoms, états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: R. THUES, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 03 octobre 2014. Relation: DIE/2014/12669. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

<i>Le Receveur

 (signé) pd: RECKEN.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Diekirch, le 08 octobre 2014.

Référence de publication: 2014156338/66.
(140177714) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

Campria Capital S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,

(anc. Campria Capital S.A. S.P.F.).

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 11.447.

L’an deux mille quatorze, le vingt-six septembre.
Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire, résidant à Luxembourg.

S’est réunie

l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme, société de gestion de patrimoine familial

«CAMPRIA CAPITAL S.A. S.P.F.», ayant son siège social à L-2138 Luxembourg, 24, rue St. Mathieu, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 11.447, constituée suivant acte reçu par
Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Junglinster, en date du 15 novembre 1973, publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations C numéro 231 du 31 décembre 1973, dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises
et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 21 décembre 2010, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C numéro 664 du 7 avril 2011.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Annick Braquet, demeurant professionnellement à L-1319

Luxembourg, 101, rue Cents.

157773

L

U X E M B O U R G

Le Président désigne comme secrétaire Madame Arlette Siebenaler, demeurant professionnellement à L-1319 Luxem-

bourg, 101, rue Cents.

L’assemblée élit comme scrutateur Mademoiselle Stéphanie Salin, demeurant professionnellement à L-2138 Luxem-

bourg, 24, rue Saint Mathieu.

Le président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions détenues par chacun d’entre eux sont indiqués

sur une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste ainsi
que les procurations seront annexées au présent acte pour être soumises aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a été dûment convoquée par voie d’annonces comprenant

l’ordre  du jour  publiées  au  Mémorial,  Recueil des  Sociétés  et  Associations,  dans  le Letzebuerger  Journal,  et dans le
Quotidien, en date des 25 août 2014 et 10 septembre 2014.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. Modification de la dénomination de la société et modification de l’article premier des statuts.
2. Abandon du statut de société de gestion de patrimoine familial et modification de l’article 4 des statuts relatif à

l’objet social comme suit:

«La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts

de propriété immobiliers ou mobiliers. La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement
ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’adminis-
tration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.»

3. Suppression du dernier alinéa de l’article 5 des statuts.
4. Modification de l’article 13 des statuts.
5. Divers.
IV.- Qu'il appert de ladite liste de présence que sur les 1.500 actions en circulation, 1 action est représentée à la

présente assemblée.

Une première assemblée générale extraordinaire convoquée suivant les modalités indiquées dans le procès-verbal de

cette assemblée, et ayant le même ordre du jour que la présente assemblée, s’est tenue en date du 18 août 2014 et n’a
pu délibérer sur l’ordre du jour pour défaut du quorum légal requis.

En vertu des articles 67 et 67-1 de la loi concernant les sociétés commerciales, la présente assemblée est autorisée à

prendre des résolutions indépendamment de la proportion du capital représenté.

Ces faits ayant été approuvés par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes

avec effet au 1 

er

 septembre 2014:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier la dénomination de la société de sorte que l’article 1 

er

 des statuts aura désormais la

teneur suivante:

«Il existe une société anonyme luxembourgeoise, dénommée CAMPRIA CAPITAL S.A.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’abandonner le statut de société de gestion de patrimoine familial de sorte que l’article 4 des

statuts aura désormais la teneur suivante:

«La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts

de propriété immobiliers ou mobiliers. La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement
ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’adminis-
tration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de supprimer le dernier alinéa de l’article 5 des statuts.

157774

L

U X E M B O U R G

<i>Quatrième résolution

En conséquence de tout ce qui précède, l’assemblée décide également de modifier l’article 13 des statuts comme suit:
«La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouvera son application

partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire

instrumentant le présent acte.

Signé: A. BRAQUET, A. SIEBENALER, S. SALIN et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 30 septembre 2014. Relation: LAC/2014/45418. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur

 (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 6 octobre 2014.

Référence de publication: 2014156483/89.
(140176389) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

ETNA Constructions s.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. ETNA Promotions s.à r.l.).

Siège social: L-4888 Lamadelaine, 2-4, Op den Gehren.

R.C.S. Luxembourg B 57.488.

L'an deux mille quatorze, le vingt-quatre septembre.
Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.

A COMPARU:

Monsieur Toni RANTE, entrepreneur de constructions, né à Raiano (Italie) le 1 

er

 septembre 1955, demeurant à L-4888

Lamadelaine, 2, Op den Gehren,

détenteur de cinq cents (500) parts sociales.
Lequel comparant, agissant en sa qualité de seul associé de la société à responsabilité limitée "ETNA Promotions s. à

r.l." (numéro d’identité 1996 24 12 370), avec siège social à L-4888 Lamadelaine, 4, Op den Gehren, inscrite au R.C.S.L.
sous le numéro B 57.488, constituée sous la dénomination de «PROMOTIONS BOURGARD SARL» suivant acte reçu
par le notaire Georges d’HUART, alors de résidence à Pétange, en date du 16 décembre 1996, publié au Mémorial C,
numéro 152 du 28 mars 1997 et dont les statuts ont été modifiés suivant décision de l’associé unique prise en date du
10 juin 2002, publiée au Mémorial C, numéro 1275 du 3 septembre 2002 et suivant acte reçu par le notaire instrumentant
en date du 27 juin 2013, publié au Mémorial C, numéro 2209 du 10 septembre 2013, ledit acte contenant notamment
changement de la dénomination sociale en «ETNA Promotions s. à r.l.»,

a requis le notaire d'acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide de changer la dénomination de la société de «ETNA Promotions s. à r.l.» en «ETNA Cons-

tructions s. à r.l.» et en conséquence de modifier l’article 1 

er

 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«  Art. 1 

er

 .  La société adopte la forme d’une société à responsabilité limitée et prend la dénomination de ETNA

Constructions s. à r.l.»

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide de modifier l’article 3 des statuts, relatif à l’objet social, pour lui donner la teneur suivante:

« Art. 3. La société a pour objet la mise en valeur de tous immeubles bâtis et non bâtis par construction, location et

vente, ainsi que tous travaux de terrassement, excavation, canalisation, asphaltage, bitumage, voirie, pavage, construction
et génie civil.

La société est autorisée à contracter des emprunts pour son propre compte et à accorder tous cautionnements ou

garanties.

La société pourra effectuer toutes activités et opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières, immo-

bilières  ou  autres  se  rattachant  directement  ou  indirectement  à  son  objet  social  ou  susceptibles  d'en  favoriser  la
réalisation.»

157775

L

U X E M B O U R G

<i>Troisième résolution

L’associé unique décide de fixer désormais l’adresse de la société à L-4888 Lamadelaine, 2-4, Op den Gehren.
Le comparant déclare, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu’elle a été modifiée par la suite, être le

bénéficiaire réel de la société faisant l’objet des présentes et agir pour son propre compte et certifie que la société ne se
livre pas et ne s’est pas livrée à des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de
la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
(blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l’article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont estimés à environ mille euros (€ 1.000.-).

DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: RANTE, A. WEBER.
Enregistré à Capellen, le 2 octobre 2014. Relation: CAP/2014/3733. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): NEU.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande.

Bascharage, le 8 octobre 2014.

Référence de publication: 2014156561/55.
(140178199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

ColMassyRedLux Genpar, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.600,00.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.

R.C.S. Luxembourg B 172.393.

Suivant décision du gérant unique, en date du 1 

er

 août 2014, le siège social de la société a été transféré du 2-4 avenue

Marie-Thérèse L-2132 Luxembourg au 22, rue Marie-Adélaïde L-2128 Luxembourg, avec effet au 1 

er

 août 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2014157903/13.
(140179133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2014.

Capital Safety Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 165.563.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 09 octobre 2014.

Référence de publication: 2014157888/10.
(140179278) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2014.

Calimax 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 24, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 178.229.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 09 octobre 2014.

Référence de publication: 2014157887/10.
(140179257) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2014.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

157776


Document Outline

2eRRe

A.F.C. Sàrl

Calimax 2 S.A.

Campria Capital S.A.

Campria Capital S.A. S.P.F.

Capital Safety Group S.à r.l.

ColMassyRedLux Genpar

ETNA Constructions s.à r.l.

ETNA Promotions s.à r.l.

Niam Core-Plus Luxembourg S.à r.l.

NW Europe Holdings S.à r.l.

Polyusus Lux IV S.à r.l.

RREEF EuCoReF 1 S.à.r.l.

RW Holdings S.à r.l.

Schwartz Rolladen und Fenster GmbH

Terre Bleue S.A.

Thor Trading, S.à r.l.

Thot SA

Timken Lux Holdings II S.à r.l.

TrendConcept Fund S.A.

TrendConcept Fund S.A.

Tyco Electronics Holding S.à r.l.

UK Logistics Topco I S.à r.l.

UK Students 60 CR S.à r.l.

UL Investment S.A.

Universal Securitisation Solutions

Upstream Systems S.A.

Urano LuxCo S.à r.l.

Urban&amp;Civic Holdings S.à r.l.

USD Rail International S.à r.l.

Valdabbio S.A.

Vanille et Chocolat

VCP VII Luxco 7 S.à r.l.

Vector Holdings S.à r.l.

Verne Holding S.à r.l.

Villandry Conseil &amp; Participations S.A.

Vision h. s.à r.l.

Voirie Environnement S.à r.l.

VP investments Sàrl

Wen Hua S.à r.l.

Whitehall Bear S.à r.l.

Whitehall European RE 6 S.à r.l.

Whitehall European RE 7 S.à r.l.

Whitehall European RE 9 S.à r.l.

Whitehall French RE 1 S.à r.l.

Whitehall French RE 2 S.à r.l.

Whitehall French RE 3 S.à r.l.

Wilh. F. Schmitz Electro Technique G.m.b.H.

Wind Infrastructure Holding S.à r.l.

Yessod S.A.