logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 3251

5 novembre 2014

SOMMAIRE

Activ Fiduciaire S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156002

Agence Fonseca Immobilier Luxembourg

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156033

Anoa Capital S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156002

Anoa Capital S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156038

Antalan Group Holding S.A.  . . . . . . . . . . . .

156045

AOF3 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156040

Asco Energie Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

156002

Ascot Luxembourg Holdings 2 S.à r.l.  . . . .

156002

Belux Bois S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156044

Biminvest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156003

Biminvest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156042

Caballo Fello S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156043

CCH S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156003

CNF SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156007

DF Group SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156046

Dream Luxco S.C.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156004

Dundeal (International) 24 S.à r.l.  . . . . . . .

156006

ECommerce Holding II S.à r.l. . . . . . . . . . . .

156008

EcoTree S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156003

E.D. Maler- Fassadenarbeiten G.m.b.h. . . .

156047

F9 A Chateau S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156007

FWP Lux Feeder Gamma Sàrl  . . . . . . . . . .

156003

Garrison Earlsfort I S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

156006

GOLDENBURY (Luxembourg) S.A.  . . . . .

156004

HTTS Management Global Partner S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156004

ICG International Computing Group S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156034

ID Concept S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156005

Imprimerie Gérard Klopp S.à r.l.  . . . . . . . .

156005

INOV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156006

McKesson Information Solutions Holdings

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156005

Mill Luxembourg Holdings 1  . . . . . . . . . . . .

156005

Nova Express S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156006

Nova Express S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . .

156006

NSAM Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

156007

Oxford Instruments Funding (Luxem-

bourg) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156004

Oxford LS 1 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156007

Oxford LS 2 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156045

Oxford Street Capital 1 S.à r.l.  . . . . . . . . . .

156007

Oxford Street Capital 2 S.à r.l.  . . . . . . . . . .

156045

Oxford Street Capital S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

156007

Paneuropa Real Estate InvestCo . . . . . . . . .

156004

Pasha International . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156048

Pinkerton S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156003

Project Oxford LS S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

156007

Reference Automobile S.A.  . . . . . . . . . . . . .

156005

Sensata Investment Company S.C.A.  . . . .

156036

SICAV II (Lux)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156002

SKM Krieger S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156008

Vitus Arendahl S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156008

156001

L

U X E M B O U R G

Asco Energie Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 187.899.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 septembre 2014.

Référence de publication: 2014151881/10.
(140174060) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2014.

Ascot Luxembourg Holdings 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 186.832.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 octobre 2014.

Référence de publication: 2014151882/10.
(140174267) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2014.

Activ Fiduciaire S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2328 Luxembourg, 20, rue des Peupliers.

R.C.S. Luxembourg B 143.688.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Référence de publication: 2014151891/10.
(140173835) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2014.

Anoa Capital S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 155.833.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Référence de publication: 2014151902/10.
(140173878) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2014.

SICAV II (Lux), Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 107.426.

Koordinierte Statuten hinterlegt beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 29. September 2014.

Für gleichlautende Abschrift
<i>Für die Gesellschaft
Maître Carlo WERSANDT
<i>Notar

Référence de publication: 2014152391/14.
(140173708) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2014.

156002

L

U X E M B O U R G

CCH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9746 Drauffelt, 2A, Welzerstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 166.388.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 octobre 2014.

Référence de publication: 2014151971/10.
(140173963) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2014.

Biminvest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 95.821.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Référence de publication: 2014151939/10.
(140173981) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2014.

EcoTree S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9631 Allerborn, 22A, Maison.

R.C.S. Luxembourg B 158.435.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 octobre 2014.

Référence de publication: 2014152018/10.
(140173511) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2014.

FWP Lux Feeder Gamma Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 475.000,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 188.298.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 septembre 2014.

Référence de publication: 2014152072/10.
(140174002) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2014.

Pinkerton S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 167.590.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2013, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Pinkerton S.A.
Société anonyme
Signatures
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2014153888/14.
(140175402) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2014.

156003

L

U X E M B O U R G

Paneuropa Real Estate InvestCo, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 4.998.575,00.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 118.879.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 03/10/2014.

<i>Pour: Paneuropa Real Estat InvestCo
Société à responsabilité limitée
Experta Luxembourg
Société anonyme

Référence de publication: 2014153873/14.
(140175504) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2014.

GOLDENBURY (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 76.565.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 octobre 2014.

Référence de publication: 2014152095/10.
(140174147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2014.

Oxford Instruments Funding (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 190.183.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 30 septembre 2014.

Référence de publication: 2014152267/10.
(140173799) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2014.

Dream Luxco S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 163.056.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 septembre 2014.

Référence de publication: 2014152002/10.
(140174086) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2014.

HTTS Management Global Partner S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 137.497.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 octobre 2014.

Référence de publication: 2014152114/10.
(140174003) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2014.

156004

L

U X E M B O U R G

ID Concept S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6910 Roodt-sur-Syre, 7, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 121.990.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 30 septembre 2014.

Référence de publication: 2014152135/10.
(140173801) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2014.

Imprimerie Gérard Klopp S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5691 Ellange, 34, Zone d'Activités Economiques Le Triangle Vert.

R.C.S. Luxembourg B 71.669.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 29 septembre 2014.

Référence de publication: 2014152144/10.
(140173796) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2014.

Mill Luxembourg Holdings 1, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 19.500,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 176.460.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 septembre 2014.

Référence de publication: 2014152210/10.
(140173597) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2014.

McKesson Information Solutions Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 81.541.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 30 septembre 2014.

Référence de publication: 2014152225/10.
(140173798) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2014.

Reference Automobile S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3313 Bergem, 76, Grand Rue.

R.C.S. Luxembourg B 183.879.

<i>Extrait du Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue à Schifflange, le 01/10/2014

Le Conseil d'Administration de la société REFERENCE AUTOMOBILE SA inscrite au RC sous le numéro B183.879,

réuni au siège de la prédite société le 1 

er

 octobre 2014, a pris à l'unanimité la résolution suivante:

1. transférer le siège social de la société de L.3895 Foetz, rue de l'Industrie, coin rue des Artisans à L.3313 BERGEM,

76 Grand Rue à compter du 1 

er

 octobre 2014.

Pour extrait conforme

Schifflange, le 1 

er

 octobre 2014.

Référence de publication: 2014153939/14.
(140175625) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2014.

156005

L

U X E M B O U R G

Garrison Earlsfort I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 188.922.

Les statuts coordonnés au 25 septembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Marc Loesch
<i>Notaire

Référence de publication: 2014152074/12.
(140174115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2014.

Dundeal (International) 24 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 9A, rue Robert Stumper.

R.C.S. Luxembourg B 183.055.

Les statuts coordonnés au 21 août 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Marc Loesch
<i>Notaire

Référence de publication: 2014152004/11.
(140174193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2014.

Nova Express S.A., SPF, Société Anonyme Soparfi,

(anc. Nova Express S.A.).

Siège social: L-2172 Luxembourg, 29, rue Alphonse Munchen.

R.C.S. Luxembourg B 66.132.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 1 

er

 octobre 2014.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2014152260/11.
(140173983) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2014.

INOV, Société Anonyme.

Siège social: L-1836 Luxembourg, 23, rue Jean Jaurès.

R.C.S. Luxembourg B 170.308.

<i>Extrait aux fins de publication du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire reportée du 16 septembre 2014

L’assemblée prend note du changement d’adresse du Commissaire aux Comptes, à savoir: CHESTER &amp; JONES Sàrl,

RCS Luxembourg B 120.602, 14 rue Bernard Haal, L-1711 Luxembourg.

Dandois &amp; Meynial

<i>Assemblée générale ordinaire reportée du 16 septembre 2014

LISTE DE PRESENCE

Actionnaires

Nombre

d’actions

Signature

M. Farid MERHEJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310 Représenté par:

Total (100%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

Me Antoine Meynial / Mme Danielle Buche / Mme Stéphanie Ragni
<i>Le Président / La Secrétaire / La Scrutatrice

Référence de publication: 2014152148/20.
(140173863) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2014.

156006

L

U X E M B O U R G

F9 A Chateau S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 33, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 174.986.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 septembre 2014.

Référence de publication: 2014152073/10.
(140174126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2014.

NSAM Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 18.750,00.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 187.196.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 octobre 2014.

Référence de publication: 2014152262/10.
(140174243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2014.

Oxford Street Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Project Oxford LS S.à r.l.).

Siège social: L-1258 Luxembourg, 22, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 171.450.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 1 

er

 octobre 2014.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2014152270/11.
(140173851) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2014.

Oxford Street Capital 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Oxford LS 1 S.à r.l.).

Siège social: L-1258 Luxembourg, 22, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 171.459.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 1 

er

 octobre 2014.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2014152271/11.
(140174174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2014.

CNF SA, Société Anonyme.

Siège social: L-7634 Medernach, 3, Schnepperkopp.

R.C.S. Luxembourg B 177.211.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est tenue le 4 septembre 2014 que:
1) L'assemblée générale révoque de sa qualité d'administrateur et d'administrateur-délégué de la société:

156007

L

U X E M B O U R G

- Monsieur Manuel DE CASTRO FREITAS, salarié, né le 24 mars 1959 à Travassos/Fafe (Portugal), demeurant à L-

7570 MERSCH, 54A, rue Nicolas Welter, avec effet immédiat.

2) L'assemblée générale nomme comme administrateur de la société:
- Monsieur André DE JESUS GONCALVES, étudiant, né le 24 juillet 1996 à Ettelbruck, demeurant à L-9090 WARKEN,

30, rue de Welscheid, qui accepte.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblé générale des actionnaires qui se tiendra en 2019.
3) L'assemblée générale nomme comme directeur du département peintre/façadier de la société:
- Monsieur Mariusz Tomasz SZYMANIAK, peintre/façadier, né le 13 septembre 1969 à Jelenia Gora (Pologne), de-

meurant à L- 7791 BISSEN, 16, rue de Roost, qui accepte.

Il est nommé pour une durée indéterminée, avec tous pouvoirs d'engager la société en toutes circonstances.
La gestion journalière sera assurée comme suit:
- pour toute opération ne dépassant pas le montant de deux mille euros (2.000,- EUR) par sa seule signature;
- pour toute opération dépassant le montant de deux mille euros (2.000,- EUR) par sa signature conjointement avec

celle d'un administrateur.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Medernach, le 4 septembre 2014.

<i>Pour la société
C.F.N GESTION S.A.
20, Esplanade - L-9227 Diekirch
Adresse postale:
B.P. 80 - L-9201 Diekirch
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014151463/33.
(140173431) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2014.

Vitus Arendahl S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. SKM Krieger S.à r.l.).

Siège social: L-9177 Niederfeulen, 22, route de Bastogne.

R.C.S. Luxembourg B 155.756.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Dudelange.

Carlo GOEDERT
<i>Notaire

Référence de publication: 2014152459/12.
(140174012) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2014.

ECommerce Holding II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1736 Luxembourg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 177.435.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-seventh day of the month of August;
Before the undersigned notary Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg);

THERE APPEARED:

1. Global Fin Tech Holding S.à r.l. a limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing

under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
(Registre de Commerce et des Sociétés) under number B 184.665, having its registered office at 7, avenue J.P. Pescatore,
L-2324 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (hereinafter “Global Fin Tech Holding”),

being the holder of twelve thousand four hundred ninety-nine (12,499) common shares and five thousand two hundred

fifty (5,250) series A shares,

here represented by Mr. Luis AGUERRE ENRÍQUEZ, Doctor en Derecho, professionally residing in Luxembourg, by

virtue of a proxy, given in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on August 21, 2014;

156008

L

U X E M B O U R G

2.  Bambino  53.  V  V  UG  (haftungsbeschränkt),  a  limited  liability  company  (Unternehmergesellschaft  (haftungsbes-

chränkt)) existing under the laws of Germany registered with the commercial register at the local court of Charlottenburg,
Germany, under no. HRB 126893 B, having its registered address at Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Germany (hereinafter
“Bambino 53. V V”),

being the holder of one (1) common share,
here represented by Mr. Luis AGUERRE ENRÍQUEZ, pre-named, by virtue of a proxy, given in Berlin, Germany, on

August 21, 2014;

3. HV Holtzbrinck Ventures Fund V GmbH &amp; Co. KG, a limited partnership (Kommanditgesellschaft) under the laws

of Germany with its statutory seat in Munich, Germany, registered with the commercial register (Handelsregister) at the
local court of Munich (Amtsgericht München), Germany, under no. HRA 98863, having its business address at Kaiserstraße
14b, 80801 Munich, Germany, represented by its general partner, HV Holtzbrinck Ventures Holding GmbH, a limited
liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) existing under the laws of Germany, registered with the com-
mercial  register  at  the  local  court  of  Munich,  Germany,  under  no.  HRB  185098  B,  having  its  registered  address  at
Kaiserstraße 14 b, 80801 Munich, Germany, (hereinafter “Holtzbrinck”),

being the holder of three thousand six hundred twenty-five (3,625) series A shares, eight hundred forty-four (844)

series B shares and eight hundred fifty-four (854) series C shares,

here represented by Mr. Luis AGUERRE ENRÍQUEZ, pre-named, by virtue of a proxy, given in Munich, Germany, on

August 21, 2014;

4. AI Lendico Holdings LLC, a limited liability company under the laws of Delaware, United States of America, registered

with the Secretary of State of the state of Delaware under registration number 5482207, with its statutory seat in 2711
Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, United States of America (hereinafter “Access”),

being the holder of three thousand six hundred twenty-five (3,625) series A shares, eight hundred forty-four (844)

series B shares, and eight hundred fifty-four (854) series C shares,

here represented by Mr. Luis AGUERRE ENRÍQUEZ, pre-named, by virtue of a proxy, given in London, England, on

August 20, 2014;

5. TJT (B) (Bermuda) Investment Company Ltd., a limited liability company under the laws of Bermuda with its statutory

seat in Hamilton, Bermuda, having its business address at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, Bermuda HM11
(hereinafter, “TJT”),

being the holder of four hundred (400) series C shares,
here represented by Mr. Luis AGUERRE ENRÍQUEZ, pre-named, by virtue of a proxy, given in Bermuda, on August

22, 2014;

6. Mr. David W. Zalaznick, born in New York, United States of America, on 16 April 1954, professionally residing in

9 West 57 

th

 Street - 33 

rd

 Floor, New York, NY 10019, USA (hereinafter “DZ”),

being the holder of four hundred (400) series C shares,
here represented by Mr. Luis AGUERRE ENRÍQUEZ, pre-named, by virtue of a proxy, given in New York, United

States of America, on August 20, 2014;

7. Aismare Lux Holdings S.à r.l. a limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing

under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register
(Registre de Commerce et des Sociétés) under number B 176.544, having its registered office at 6C, rue Gabriel Lippmann,
L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg (hereinafter “Aismare”),

being the holder of eight hundred (800) series C shares,
here represented by Mr. Luis AGUERRE ENRÍQUEZ, pre-named, by virtue of a proxy, given in Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg, on August 22, 2014;

8. FEC Lux S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the

laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register (Registre de
Commerce et des Sociétés) under number B 173.487, having its registered office at 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (hereinafter “FEC”),

being the holder of one thousand nine hundred seventy-five (1,975) series C shares,
here represented by Mr. Luis AGUERRE ENRÍQUEZ, pre-named, by virtue of a proxy, given in Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg, on August 21, 2014; and

9. Bambino 110. V V UG (haftungsbeschränkt), a limited liability company (Unternehmergesellschaft (haftungsbes-

chränkt)) existing under the laws of Germany registered with the commercial register at the local court of Charlottenburg,
Germany, under no. HRB 140400 B, having its registered address at Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Germany (hereinafter
“Bambino 110. V V”),

becoming the holder of eight hundred twenty (820) series D shares and participating for items 4 et seqq. of the agenda,
here represented by Mr. Luis AGUERRE ENRÍQUEZ, pre-named, by virtue of a proxy, given in Berlin, Germany, on

August 21, 2014.

156009

L

U X E M B O U R G

The said proxies, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary will remain annexed

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The parties listed under 1. to 8. (the “Existing Shareholders”) are all the shareholders, representing the entire share

capital of ECommerce Holding II S.à r.l. (the “Company”), a société à responsabilité limitée incorporated and existing
under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg,
Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 177.435
and incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on 7 May 2013, published in the Memorial C, Recueil
des Sociétés et Associations number 1651 dated 10 July 2013. The articles have been amended for the last time by deed
of the undersigned notary on 28 July 2014, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
The articles of association have not been amended since.

The Existing Shareholders representing the entire share capital declare having waived any notice requirement, the

general meeting of shareholders is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the following agenda
whereby Bambino 110. V V participates and votes for the purpose of items 4 et seqq. of the following Agenda only:

<i>Agenda

1. Decision to create one (1) additional class of shares, referred to as the series D shares (hereinafter “Series D

Shares”), with a nominal value of one euro (EUR 1) each, and to hence have five (5) classes of shares in total, divided into
common shares, series A shares, series B shares, series C shares and Series D Shares.

2. Acceptance of Bambino 110. V V UG (haftungsbeschränkt), a limited liability company (Unternehmergesellschaft

(haftungsbeschränkt)) existing under the laws of Germany registered with the commercial register at the local court of
Charlottenburg, Germany, under no. HRB 140400 B, having its registered address at Johannisstraße 20, 10117 Berlin,
Germany as new shareholder of the Company and waiver of the Existing Shareholders’ (i) preferential subscription rights
and (ii) any transfer restrictions, preemptive rights, rights of first refusal, tag-along rights, dragalong rights and or any
other rights.

3. Increase of the Company’s share capital by an amount of eight hundred twenty euro (EUR 820) so as to raise it

from its current amount of thirty-one thousand nine hundred seventy-one euro (EUR 31,971) up to thirty-two thousand
seven hundred ninety-one euro (EUR 32,791) by issuing eight hundred twenty (820) Series D Shares with a nominal value
of one euro (EUR 1) each.

4. Amendment and full restatement of the articles of association of the Company.
5. Approval and, to the extent necessary ratification of the entering into and performance of the Option Agreement

by the Company.

6. Acceptance of Joh. Berenberg, Gossler &amp; Co. KG, a financial institution having its business address at Neuer Jung-

fernstieg 20, 20354 Hamburg, Germany, as new shareholder of the Company, subject to and upon an option under the
Option Agreement and waiver of the Existing Shareholders’ (i) preferential subscription rights and (ii) any transfer res-
trictions, preemptive rights, rights of first refusal, tagalong rights, drag-along rights and or any other rights.

Having duly considered each item of the agenda, the general meeting of shareholders unanimously takes the following

resolutions:

<i>First resolution

The general meeting of shareholders decides to create one (1) additional class of shares, referred to as the series D

shares (hereinafter “Series D Shares”), with a nominal value of one euro (EUR 1) each, and to hence have five (5) classes
of shares in total, divided into common shares, series A shares, series B shares, series C shares and Series D Shares.

<i>Second resolution

The general meeting of shareholders accepts Bambino 110. V V UG (haftungsbeschränkt), a limited liability company

(Unternehmergesellschaft  (haftungsbeschränkt))  existing  under  the  laws  of  Germany  registered  with  the  commercial
register  at  the  local  court  of  Charlottenburg,  Germany,  under  no.  HRB  140400  B,  having  its  registered  address  at
Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Germany as new shareholder of the Company. The general meeting of shareholders
acknowledges the Existing Shareholders’ waiver of (i) their preferential subscription rights as set forth in article 5.3 of
the articles of association of the Company and (ii) any transfer restrictions, preemptive rights, rights of first refusal, tag-
along rights, drag-along rights and or any other rights contained in any shareholders’ agreement with respect to the
Company to which the Existing Shareholders are a party in connection with this extraordinary general meeting of sha-
reholders.

<i>Third resolution

The general meeting of shareholders resolves to increase the share capital of the Company by an amount of eight

hundred twenty euro (EUR 820) so as to raise it from its current amount of thirty-one thousand nine hundred seventy-
one euro (EUR 31,971) up to thirty-two thousand seven hundred ninety-one euro (EUR 32,791) by issuing eight hundred
twenty (820) Series D Shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.

156010

L

U X E M B O U R G

<i>Subscription

The eight hundred twenty (820) new Series D Shares have been duly subscribed by Bambino 110. V V aforementioned,

for the price of eight hundred twenty euro (EUR (820).

<i>Payment

The eight hundred twenty (820) Series D Shares subscribed by Bambino 110. V V, aforementioned, have been entirely

paid up through a contribution in cash in an amount of eight hundred twenty euro (EUR 820).

The proof of the existence and of the value of the above contribution has been produced to the undersigned notary.
The contribution in the amount of eight hundred twenty euro (EUR 820) is entirely allocated to the share capital.

<i>Fourth resolution

The general meeting of shareholders resolves to amend and fully restate the Company’s articles of association and

acknowledges that the Existing Shareholders have unanimously waived the prior consent requirement for the amendment
of the Company’s articles of association set forth by article 22.8 of the articles of association of the Company. The articles
of association shall henceforth read as follows:

A. Name - Purpose - Duration - Registered office

Art. 1. Name. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name ECommerce

Holding II S.à r.l. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning com-
mercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.

Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign

companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio.

2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it

holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the
Company.

2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by

issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.

2.4 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities

which it considers useful for the accomplishment of these purposes, in view of its realisation by sale, exchange or other-
wise.

Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 The Company may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of

shareholders adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Art. 4. Registered Office.
4.1 The registered office of the Company is established in Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by decision of the board of managers. It

may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by resolution of the shareholders,
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution

of the board of managers.

4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances

or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
traordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwiths-
tanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

B. Share capital - Shares

Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company’s share capital is set at thirty-two thousand seven hundred ninety-one Euro (EUR 32,791.00) with

a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each, represented by

5.1.1 twelve thousand five hundred (12,500) common shares (hereinafter “Common Shares”),
5.1.2 twelve thousand five hundred (12,500) series A shares (hereinafter “Series A Shares”),
5.1.3 one thousand six hundred eighty-eight (1,688) series B shares (hereinafter “Series B Shares”),

156011

L

U X E M B O U R G

5.1.4 five thousand two hundred eighty-three (5,283) series C shares (hereinafter “Series C Shares”), and
5.1.5 eight hundred twenty (820) series D shares (hereinafter “Series D Shares”, the Series A Shares, the Series B

Shares, the Series C Shares and the Series D Shares hereinafter also referred to as “Preferred Shares”).

The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by these

articles of association or by the Law.

5.2 The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.3 Each of (i) Global Fin Tech Holding S.à. r.l. (“Rocket”), (ii) HV Holtzbrinck Ventures Fund V GmbH &amp; Co. KG

(“Holtzbrinck”), (iii) AI Lendico Holdings LLC ("Access"), (iv) TJT (B) (Bermuda) Investment Company Ltd. (“TJT”), (v)
David W. Zalaznick (“DZ”), (vi) Aismare Lux Holdings S.à r.l. (“Aismare”), (vii) FEC Lux S.à. r.l. (“FEC”) and (viii) Joh.
Berenberg, Gossler &amp; Co. (“Berenberg”) if and when it becomes shareholder of the Company (Rocket, Holtzbrinck,
Access, TJT, DZ, Aismare, FEC and Berenberg jointly the “Investors” and each an “Investor”), shall be entitled to subscribe
for such amount of further shares to be issued in the course of a capital increase implementing an investment offer of a
third party (being neither a shareholder nor a company affiliated to a shareholder within the meaning of sections 15 et
seqq. German Stock Corporation Act (AktG) (a “Third Party Investor”) and which has been approved with a majority
vote of at least seventy-five percent (75 %) of the votes of all shareholders of the Company (a “Third Party Investment”)
- irrespective whether made by the Third Party Investor or one or more matching shareholders - required to maintain
up to its percentage ownership in the Company prior to such capital increase under the same terms and conditions on
which the Third Party Investment is based on. The respective Investor shall inform the Company by binding declaration
within three (3) weeks if it intends to exercise its right pursuant to the foregoing sentence of this Article 5.3 following
which the Third Party Investment (to the extent not taken up by the Investors under this Article 5.3) may proceed.

Art. 6. Shares.
6.1 The Company’s share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of

the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.

6.5 The Company may accept contributions without issuing shares or other securities in consideration and may allocate

such contributions to one or more distributable reserves. Decisions as to the use of any such distributable reserves are
to be taken by the shareholder(s) or the manager(s) as the case may be, subject to the Law and these articles of association.

Art. 7. Register of Shares - Transfer of Shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection

by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.

7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall

appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.

7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given

by the shareholders at a majority of three quarters of the share capital and subject to the provisions of any shareholders
agreement between the shareholders, if any, in particular, any rights of first refusal, rights of pre-emption or tag-along
rights or drag-along rights contained in any shareholders agreement between the shareholders. To the extent that such
approval has been granted, an additional consent to the transfer of shares is not required:

7.4.1 in any case of a transfer, assignment or any other disposal of shares by any Investor to a company affiliated to

such Investor within the meaning of sections 15 et seqq. German Stock Corporation Act (AktG);

7.4.2 in case of a sale, transfer, assignment or any other disposal of shares by any Investor to a company (x) which is

directly or indirectly Controlling, Controlled by or under common Control with (i) this Investor or (ii) by one or more
direct or indirect shareholders of the respective Investor (each a “Controlled Company”), whereas “Control” or “Con-
trolled” or “Controlling” shall mean the direct or indirect domination of the company by way of (a) managing the company
as managing shareholder, (b) holding the majority of shares or (c) holding the majority of voting rights by means of a
contractual voting pool, or (d) the unilateral ability to cause, directly or indirectly, the direction of the management and
policies of a person, whether through the ownership of voting securities or otherwise, or (y) in which the respective
Investor or one or more shareholders of such Investor has a direct or indirect majority shareholding;

7.4.3 in case of a transfer, assignment or any other disposal of shares (i) to a party acquiring shares under the simplified

employee participation or (ii) to the Company and/or any Investor pursuant to a call-option under a vesting scheme;

7.4.4 in case of any transfer, assignment or any other disposal of shares within the framework of transformation

procedures pursuant to the transformation law of Luxembourg, in particular (but without limitation) a merger of the

156012

L

U X E M B O U R G

Company, if the shareholders of the Company hold more than fifty per cent (50 %) in any surviving legal entity after such
transformation procedure.

7.5 In the cases provided for in art. 7.4.1 through 7.4.4 above, no duties to offer for sale apply, nor do any rights of

first refusal, rights of pre-emption or tag-along rights or drag-along rights in favour of other shareholders apply.

7.6 Any transfer, assignment or any other disposal of shares shall become effective towards the Company and third

parties through the notification of the transfer, assignment or any other disposal to, or upon the acceptance of the transfer,
assignment or any other disposal by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

7.7 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject

to the approval of such transfer given by shareholders holding at least three quarters of the share capital (a “Super
Majority”) (which, for these purposes, shall exclude the shares of the deceased shareholder). Such approval is, however,
not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse or any other legal
heir of the deceased shareholder.

Art. 8. Liquidation and Sale Preferences.

8.1 In case (i) of any sale of at least fifty per cent (50%) of all shares in the Company, or a swap or a take-over of the

Company in an economically comparable way in a single or series of related transactions or in close time proximity to
one another, or (ii) of the liquidation of the Company or (iii) of any sale or transfer of shares in the Company either to
third parties or other shareholders that would result in either more than fifty per cent (50%) of the share capital or more
than fifty per cent (50%) of the voting rights being owned by the acquiring party/parties (change of control) as a result of
one or more related acquisitions, (each of the events described in (i), (ii) and (iii) is hereinafter referred to as a “Liquidity
Event”), the proceeds (“Exit Proceeds”) - subject to Article 8.2 through Article 8.4 below - will be distributed in accor-
dance with Article 8.5 to the shareholders pro rata corresponding to their participation in the Liquidity Event.

8.2 On a first level (“First Level”) the holders of Series C Shares and Series D Shares shall receive an amount which

equals the amount of their respective total investment made in the Company (consisting of the nominal amount of the
Series C Shares or Series D Shares, as the case may be, acquired by that holder and any share premium and/or other
capital contribution (account 115) paid by that holder (or his predecessor in title to the relevant Shares) to the Company).
If the Exit Proceeds do not suffice for the payments to be made on the First Level, the Exit Proceeds shall be allocated
to the holders of Series C Shares and Series D Shares pro rata to the amounts that would have been allocated to the
holders of Series C Shares and Series D Shares on the First Level if the Exit Proceeds were sufficient.

8.3 On a second level (“Second Level”) the holders of Series B Shares shall receive an amount which equals the amount

of their respective total investment made in the Company (consisting of the nominal amount of the Series B Shares
acquired by that holder and any share premium and/or other capital contribution (account 115) paid by that holder (or
his predecessor in title to the relevant Shares) to the Company). If the Exit Proceeds do not suffice for the payments to
be made on the Second Level, the Exit Proceeds shall be allocated to the holders of Series B Shares pro rata to the
amounts that would have been allocated to the holders of Series B Shares on the Second Level if the Exit Proceeds were
sufficient.

8.4 On a third level (“Third Level”) the holders of Series A Shares shall receive an amount which equals the amount

of their respective total investment made in the Company (consisting of the nominal amount of the Series A Shares
acquired by that holder and any share premium and/or other capital contribution (account 115) paid by that holder (or
his predecessor in title to the relevant Shares) to the Company). If the Exit Proceeds do not suffice for the payments to
be made on the Preferred Level, the Exit Proceeds shall be allocated to the holders of Series A Shares pro rata to the
amounts that would have been allocated to the holders of Series A Shares on the Preferred Level if the Exit Proceeds
were sufficient.

8.5 After the payments on the First, the Second and the Third Level have been made, the remaining Exit Proceeds

shall be allocated on a common level (“Common Level”) to all shareholders pro rata corresponding to their participation
in the Liquidity Event. Any amounts received by any shareholder on the First, the Second and the Third Level shall reduce
the amount to be allocated to such shareholder on the Common Level and shall be allocated subsequently pursuant to
this Common Level provided that no shareholder shall be obliged to repay any amount received on the First, the Second
and the Third Level. The allocation at the Common Level shall be made until all Exit Proceeds have been distributed to
the shareholders. Irrespective of whether or not the sale of shares is made in one Liquidity Event or after the Liquidity
Event in one transaction or more transactions no shareholder shall receive for the sale of all of its shares (and shall repay
any exceeding amount to the other shareholders) an amount exceeding the higher of (i) its share in the total Exit Proceeds
or proceeds pro rata to the shares sold on a common equivalent basis or (ii) the amount allocated to such shareholder
on the First, the Second and the Third Level from a subsequent sale. All rights related to the liquidity preference stipulated
herein can only be exercised once.

8.6 The preferred allocation on the First, the Second and the Third Level applies to each of the respective Preferred

Shares as long as on the respective Preferred Shares the respective amount stipulated in Article 8.2 through Article 8.4
has not yet been distributed once.

156013

L

U X E M B O U R G

Art. 9. Redemption of Shares.
9.1 The Company may redeem its own shares. The voting rights of any of its shares held by the Company are suspended,

for as long as they are held by the Company.

9.2 Shares of a shareholder may be redeemed without such shareholder’s consent, only if:
9.2.1 insolvency proceedings are opened over the assets of the shareholder or the opening of insolvency proceedings

is rejected for lack of assets;

9.2.2 the share of a shareholder is seized or enforcement proceedings are otherwise initiated against such share and

such enforcement proceedings are not finally closed within two (2) months.

Upon receipt by such shareholder of the declaration of redemption sent by the board of managers, the shares shall

automatically be redeemed without any further action being required. The present articles together with the declaration
of redemption constitute together a valid instrument in writing for the purposes of article 190 of the Law and the Company
hereby acknowledges and accepts the transfer of the shares in such case and undertakes to register the transfer in its
share register and to proceed with the relevant filings required by law.

9.3 If the share is held by several persons, it is sufficient that the ground for redemption exists with respect to one

person; independently of this, several jointly entitled persons can only exercise the shareholders’ rights in a uniform way
through one jointly entitled person to be appointed for this purpose without undue delay after the joint entitlement
arises.

9.4 The board of managers may declare a redemption. The redemption declaration takes effect upon receipt of the

declaration by the shareholder concerned and if a respective shareholders’ resolution is adopted (except in case of Article
9.2 of these articles of association, in which no declaration by the shareholder concerned and no respective shareholders’
resolution is required).

Art. 10. Compensation for Redemption.
10.1 Redemption is made against compensation.
10.2 The compensation consists of a total amount equal to the market value of the redeemed shares. The effective

date is the date before the redemption resolution.

10.3 The compensation for redemption shall be due and payable immediately upon redemption of the shares.
10.4 The withdrawing shareholder shall not be entitled to request the Company to provide security for outstanding

amounts including interest.

10.5 In the event of dispute regarding the amount of the payable compensation for redemption, such compensation is

to be determined by an auditor as expert arbitrator who shall jointly be appointed by the shareholders. If no agreement
is reached the expert arbitrator shall be selected by the President of the Tribunal d’Arrondissement upon request of a
shareholder or of the Company. The decision of the expert arbitrator shall be binding. The costs of the expert opinion
shall be borne by the Company and the requesting shareholder in equal parts, the part allocated to such shareholder shall
be set off with the compensation for redemption and the compensation for redemption shall be reduced accordingly.
The shareholder shall bear the remaining costs in case the redemption price does not cover the costs allocated to the
shareholder for the expert opinion.

Art. 11. Request of Assignment in lieu of Redemption.
11.1 The Company may decide that, in lieu of redemption, the shareholder concerned shall transfer the shares to a

person named by the Company (including another shareholder of the Company), including also partial redemption or
partial assignment of the shares to the Company or to a person named by the Company, subject to articles 189 and 190
of the Law.

11.2 This Article 11 applies with the proviso that the compensation, as provided for in Article 10 of these articles of

association, for the shares to be assigned is owed by the person acquiring the shares and that the Company shall be liable
as a guarantor for such sum.

C. Decisions of the shareholders

Art. 12. Collective Decisions of the Shareholders.
12.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these

articles of association.

12.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
12.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise

conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case,
each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his
vote in writing.

12.4 The shareholders’ resolutions are passed in meetings. Unless mandatory law prescribes another form, they can

also be passed outside meetings in writing (including e-mail or fax) or telephone voting if such procedure is requested by
a shareholder and no other shareholder declares its dissent with the procedure within two (2) weeks towards the board
of managers of the Company in written form. If no dissent is declared within the two (2) weeks pursuant to the foregoing

156014

L

U X E M B O U R G

sentence the votes of the shareholders which are not participating in the voting shall be deemed to be cast in abstention
from voting. Written resolutions must be signed by each shareholder and the written record must be sent to each
shareholder without undue delay. Resolutions not passed in writing must be confirmed in writing. Such confirmation only
has declaratory significance.

12.5 Unless a notarial record is made of shareholders’ resolutions, a written record must be made of every resolution

passed at shareholders’ meetings (for purposes of proof, not as a precondition of validity) without undue delay, which
must state the date and form of the resolution passed, the content of the resolution and the votes cast. The written
record must be sent to each shareholder in writing without undue delay.

12.6 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of

shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by
the sole shareholder.

Art. 13. General Meetings of Shareholders.
13.1 Meetings of shareholders may be held at the registered office of the Company or at such place and time as may

be specified in the respective convening notices of meeting.

13.2  The  shareholders’  meeting  is  called  by  registered  letter  (registered  personal  delivery,  registered  delivery  or

registered letter with confirmation of receipt) to each shareholder, stating the place, date, time and agenda, with a period
of notice of at least four (4) weeks for ordinary shareholders’ meetings and at least two (2) weeks for extraordinary
shareholders’ meetings. The period of notice begins to run on the day following postage. The day of the shareholders’
meeting is not counted in the calculation of the period of notice.

13.3 If all shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived convening

requirements, the meeting may be held without prior notice.

13.4 Each shareholder is entitled to be accompanied or represented at the shareholders’ meeting by another share-

holder authorised by a written power of attorney or by a lawyer, tax advisor or auditor under a professional duty of
confidentiality.

13.5 Unless a notarial record is made of the negotiations of the shareholders’ meeting, a written record must be made

concerning the course of the meeting (for purposes of proof, not as a precondition of validity), which must state the place
and date of the meeting, the participants, the items on the agenda, the main content of the negotiations and the share-
holders’ resolutions. The written record must be signed by all shareholders present or represented in the shareholders’
meeting (for purposes of proof, not as a precondition of validity). Each shareholder must be sent a copy of the written
record.

Art. 14. Quorum and Vote.
14.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
14.2 A shareholders’ meeting only constitutes a quorum if at least fifty per cent (50%) of the share capital is represented.

Save for a higher majority provided in these articles of association or by Law, collective decisions of the Company’s
shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share
capital. If there is no quorum, a new shareholders’ meeting with the same agenda must be called without undue delay in
compliance with Article 13.2. This shareholders’ meeting then shall constitute a quorum regardless of the share capital
represented, if this was pointed out in the notice calling the meeting and the decisions shall be taken at the majority of
the votes cast.

Art. 15. Change of Nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous

consent.

Art. 16. Amendments of Articles of Association. Any amendment of these articles of association requires the approval

of (i) a majority in number of shareholders (ii) who are also a Super Majority.

Art. 17. Shareholders’ Resolutions Requiring Specific Majority.
17.1 Shareholders’ Resolutions regarding the following subjects must be taken by a Super Majority:
17.1.1 disposition of all Company’s assets or of a significant part of the Company’s assets including the resolution with

respect to the liquidation of the Company;

17.1.2 resolution with respect to the merger, separation and transformation of the Company;
17.1.3  conclusion  of  intra-group  agreements  (Unternehmensverträge  within  the  meaning  of  sections  291  et  seqq.

German Stock Corporation Act (AktG));

17.1.4 conclusion of company participations (for the avoidance of doubt, other than by way of disposal of shares) of

any kind including silent partnerships and all agreements by which the other contractual party is granted a participation
in the Company’s profit or any payment that is dependent on the amount of the Company’s profit; this does not include
agreements with shareholders or employees of the Company, including agreements concluded in light of a prospective

156015

L

U X E M B O U R G

status as shareholder or employee, as well as agreements with third parties within the ordinary course of business, e.g.
agreements between the Company and advertising partners.

17.2 Resolutions regarding the following subjects must be taken by a Super Majority and also require the prior consent

of the Investors.

17.2.1 exclusion of subscription rights in case of capital increases;
17.2.2 acquisition of the Company’s own shares, with the exception of acquisitions in accordance with Article 9.2 and

transfers in accordance with Article 11.1 of these articles of association.

17.3 Whenever the capital of the Company is divided into different classes of shares the specific rights and obligations

attached to any class may be varied or abrogated with the unanimous consent in writing of the shareholders who hold
all the issued shares of that class.

D. Board of managers - Advisory board

Art. 18. Powers of the Sole Manager - Composition and Powers of the Board of Managers.
18.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers

form a board of managers.

18.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not

expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of
association is to be construed as a reference to the “sole manager”.

18.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any

actions necessary or useful to fulfil the Company’s corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the
Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.

Art. 19. Election, Removal and Term of Office of Managers.
19.1 The manager(s) shall be elected by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration

and term of office.

19.2 The managers shall be elected and may be removed from office at any time, with or without cause.
19.3 The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two (2) different classes, being class A

managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant
shareholders resolutions and the managers be identified with respect to the class they belong.

Art. 20. Vacancy in the Office of a Manager.
20.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or

otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the  replaced manager  by the remaining  managers  until  the  next  meeting  of  shareholders which  shall resolve on the
permanent appointment, in compliance with the applicable legal provisions.

20.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company’s sole manager, such vacancy must be filled without undue

delay by the general meeting of shareholders.

Art. 21. Convening Meetings of the Board of Managers.
21.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held

at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.

21.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers at least twenty-four (24)

hours in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such document being
sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined
in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.

21.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive

any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of
managers.

Art. 22. Management.
22.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not

need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

22.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may

appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any
such meeting.

22.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either

in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.

156016

L

U X E M B O U R G

22.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other

means of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis
and allowing an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a
participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.

22.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or

represented at a meeting of the board of managers.

22.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,

if any, shall not have a casting vote. In the event however the general meeting of shareholders has appointed different
classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only
be validly taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which
may be represented).

22.7 The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in

writing, by facsimile, electronic mail o r any other similar means of communication. Each manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be
the date of the last signature.

22.8 The managers shall require the consent of at least two (2) of the shareholders Rocket, Holtzbrinck, Access, TJT,

DZ, Aismare, FEC and Berenberg (if Berenberg is at the relevant time a holder of Shares), which at the relevant time
hold jointly more than fifty per cent (50%) of the Company’s registered share capital (the “Investor Majority”) for the
legal transactions and measures specified below. No consent is required if such legal transactions and measures have been
precisely defined and have in advance been approved by an adopted budget with the consent of the Investor Majority:

22.8.1 formation, acquisition, closure or disposal of enterprises or partialbusinesses;
22.8.2 amendment of statutes, these articles of association, shareholder agreements and similar contracts as well as

exercise (or waiver) of shareholders’ rights in companies in which an interest is held;

22.8.3 acquisition, sale and encumbrance of real estate and similar rights or rights in real estate;
22.8.4 establishment, relocation and closure of branch establishments and places of business;
22.8.5 modification of the fields of business of the Company and the termination of existing and commencement of

new fields of business (Geschäftsfelder);

22.8.6 approval of the annual plan, in particular the budget plan for each following year;
22.8.7 assumption of sureties, guarantees or similar liabilities in excess of an amount of two hundred thousand Euros

(EUR 200,000.00) in aggregate;

22.8.8 granting of loans in excess of two hundred thousand Euros (EUR 200,000.00) in the individual case, excluding,

however, such loans between the Company and direct and indirect subsidiaries of the Company;

22.8.9 conclusion and termination of credit and loan agreements and other financial agreements in excess of two

hundred thousand Euros (EUR 200,000.00) in the individual case and amendments to the credit framework and extraor-
dinary repayments, excluding, however, such agreements between the Company and direct and indirect subsidiaries of
the Company;

22.8.10 futures transactions concerning currencies, securities and exchangetraded goods and rights as well as other

transactions with derivative financial instruments;

22.8.11 granting, introduction and amendment of pension commitments of any kind;
22.8.12 conclusion, amendment and dissolution of employment contracts providing for a remuneration in excess of

one hundred fifty thousand Euros (EUR 150,000) per year;

22.8.13 promise or granting of bonuses and gratuities of any kind outside of existing employment contracts as well as

payment of advances or grant of loans to managers and employees in excess of fifty thousand Euros (EUR 50,000) in the
individual case;

22.8.14 conclusion, amendment or termination of Company collective agreements, works agreements (of substantial

importance) and of general guidelines regarding the Company pension scheme;

22.8.15 institution and termination of legal disputes, in particular, arbitration proceedings involving a judicial amount

in controversy of more than ten thousand Euros (EUR 10,000.00) in the individual case;

22.8.16 acquisition, disposition and/or licensing of rights of use of any kind with respect to intellectual property rights

including copyrights or any other property rights as well as the passing on of know-how for the independent exploitation
by  the  enterprise  and/or  a  third  party,  as  well  as  the  grant  or  acquisition  of  licences,  as  well  as  the  amendment  of
agreements with respect thereto, excluding, however, such dispositions between the Company and direct and indirect
subsidiaries of the Company;

22.8.17 granting of a power of attorney, by which a proxy grants power of attorney to another proxy, in order to

conclude an agreement with him at the expense of the Company;

22.8.18 transactions of the Company and its investment companies with affiliated legal entities and individuals. As such

shall be deemed to be direct or indirect shareholders of the Company (including, for the avoidance of doubt, European
Founders Fund GmbH (“EFF”) and EFF’s direct and indirect shareholders (i.e. the Samwer brothers), but excluding any

156017

L

U X E M B O U R G

direct or indirect shareholders of Holtzbrinck and/or Access and/or TJT and/or DZ and/or Aismare and/or FEC and/or
Berenberg (if Berenberg is at the relevant time a holder of Shares)), affiliated companies pursuant to sections 15 et seqq.
German Stock Corporation Act (AktG) as well as relatives pursuant to section 15 German Tax Code (AO) of direct or
indirect shareholders, as far as the latter (except EFF and EFF’s direct and indirect shareholders) - individually or jointly
- hold, directly or indirectly, a majority interest. The consent requirement pursuant to this Article 22.8.18 does not apply
if the transaction belongs to the ordinary course of business of the Company and is at arm’s length;

22.8.19 changing of the Company’s auditors;
22.8.20 granting, setting up or amending any employee incentive scheme (including the grant of any share options)

outside the existing simplified employee participation agreed upon between the shareholders in a shareholders’ agree-
ment;

22.8.21 exercise of voting rights and other rights in a company in which the Company is a shareholder to the extent

that this exercise would require the consent of the Investor Majority under these articles of association if the Company
was concerned, i.e. according to this Article 22.8 or Article 17.

22.9 If the consent is required as aforesaid for the acquisition, sale or encumbrance of objects, the consent is also

required for the contractual obligation relating thereto. The shareholders’ meeting may by resolution determine further
transactions and measures requiring the consent of the Investor Majority. The Investor Majority may give its consent also
in advance for certain groups and kinds of transactions and measures.

22.10 The shareholders may by shareholders’ resolution adopt rules of procedure for the managers.
22.11 The management shall ensure that, as far as legally possible, the regulations in this Article 22 apply in the same

manner to all related companies in which the Company holds a majority interest, directly or indirectly, at present or in
the future.

Art. 23. Minutes of the Meeting of the Board of Managers; Minutes of the Decisions of the Sole Manager.
23.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by

the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. In the event the general meeting of
shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) under the joint
signature of one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation). Copies or excerpts
of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if any, or
by any two (2) managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers
(namely class A managers and class B managers) under the joint signature of one (1) class A manager and one (1) class B
manager (including by way of representation).

23.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or

excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.

Art. 24. Dealing with Third Parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the

signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers;
in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A manager
and class B manager), the Company will only be validly bound by the joint signature of at least one (1) class A manager
and one (1) class B manager (including by way of representation) or (ii) by the joint signatures or the sole signature of
any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such
delegation.

Art. 25. Advisory Board.
25.1 The Company shall have an advisory board. The shareholders’ meeting may by way of an unanimous shareholders’

resolution increase or decrease the number of voting members of the advisory board, and provided further that Rocket
shall not be entitled to nominate more than four (4) voting members unless Rocket increases its percentage holding in
the Company.

25.2 The shareholders’ meeting shall only set and/or amend rules of procedure for the advisory board by way of a

unanimous shareholders’ resolution.

25.3 The voting members of the advisory board shall be nominated, withdrawn or replaced by each member’s res-

pective appointing shareholder by written notification towards the Company as follows:

25.3.1 Four (4) voting members of the advisory board shall be nominated by the shareholder Rocket in its sole dis-

cretion;

25.3.2 One (1) voting member of the advisory board shall be nominated by the shareholder Holtzbrinck in its sole

discretion;

25.3.3 One (1) voting member of the advisory board shall be nominated by the shareholder Access in its sole discretion;
25.3.4 One (1) voting member of the advisory board shall be nominated by the shareholder Aismare in its sole dis-

cretion; and

25.3.5 One (1) voting member of the advisory board shall be nominated by the shareholder FEC in its sole discretion.
25.4 The advisory board has voting and non-voting members as observers.

156018

L

U X E M B O U R G

25.5 The advisory board shall have a chairman and a deputy chairman. A voting member nominated by Rocket shall

be the chairman of the advisory board. The rules of procedure of the advisory board may provide for further provisions
in particular on the self organization of the advisory board. The advisory board shall adopt resolutions with the simple
majority of votes cast. The advisory board shall hold meetings on a regular basis, at least once every calendar quarter.

25.6 The advisory board shall be competent for advising the Company’s managers on the strategy and operational

matters and shall discuss with the managers the budget of the Company.

25.7 The advisory board is not a supervisory board within the meaning of article 60bis-11 et seq. of the Law.

E. Audit and supervision

Art. 26. Auditor(s).
26.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company

shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.

26.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting

of shareholders.

26.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
26.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d’entreprises agréé

(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies’ register and the
accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.

26.5 An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its

approval.

F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends

Art. 27. Financial Year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end

on the thirty-first of December of the same year.

Art. 28. Annual Accounts and Allocation of Profits.
28.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of

the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.

28.2 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve.

This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten
per cent (10%) of the share capital of the Company.

28.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the

contributing shareholder agrees with such allocation.

28.4 In case of a share capital reduction, the Company’s legal reserve may be reduced in proportion so that it does

not exceed ten per cent (10%) of the share capital.

28.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the

remainder of the Company’s annual net profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.

28.6 Subject to Article 8, distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they

hold in the Company.

Art. 29. Interim Dividends - Share Premium and Assimilated Premiums.
29.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared

by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed shall
be allocated where applicable in accordance with the provisions of Article 8 and Article 28.6 and may not exceed realized
profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable reserves, but decreased
by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles of association do not
allow to be distributed.

29.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the share-

holders subject to the provisions of the Law and these articles of association.

G. Liquidation

Art. 30. Liquidation. In the event of dissolution of the Company in accordance with Article 3.2 of these articles of

association, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting
of shareholders deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless other-
wise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realization of the assets and payment of the
liabilities of the Company.

156019

L

U X E M B O U R G

H. Final clause - Governing law

Art. 31. Governing Law.
31.1 All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the Law and any

shareholders’ agreement which may be entered into from time to time between the shareholders and the Company, and
which may supplement certain provisions of these articles. Where any matter contained in these articles conflicts with
the provisions of any shareholders’ agreement, such shareholders’ agreement shall prevail inter partes and to the extent
permitted by Luxembourg law.

31.2 These articles are worded in English followed by a German translation; in case of divergence between the English

and the German text, the English version shall prevail.

<i>Fifth resolution

The general meeting of shareholders approves and, to the extent necessary, ratifies the entering into and performance

of the option agreement entered into by the Company, the Existing Shareholders, Bambino 110 and Joh. Berenberg,
Gossler &amp; Co. KG, a financial institution having its business address at Neuer Jungfernstieg 20, 20354 Hamburg, Germany
(“Berenberg”) on or about 28 August 2014 (the “Option Agreement”).

<i>Sixth resolution

The general meeting of shareholders resolves to accept Berenberg as new shareholder of the Company, subject to

and upon exercise of an option granted to Berenberg pursuant to the Option Agreement. The general meeting of sha-
reholders acknowledges the Existing Shareholders’ waiver of (i) their preferential subscription rights as set forth in article
5.3 of the articles of association of the Company and (ii) any transfer restrictions, preemptive rights, rights of first refusal,
tag-along rights, dragalong rights and or any other rights contained in any shareholders’ agreement with respect to the
Company to which the Existing Shareholders are a party in connection with this extraordinary general meeting of sha-
reholders.

There being no further business, the meeting is closed.

<i>Costs and expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are

estimated at approximately one thousand eight hundred euro (EUR 1,800.-).

<i>Statement

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,

the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing party and
in case of divergence between the English and the German text, the English version will prevail.

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the proxy-holder of the appearing parties, acting as said before, known to the notary

by name, first name, civil status and residence, the said proxy-holder has signed with Us the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausendvierzehn, am siebenundzwanzigsten Tag des Monats August;
Vor dem unterzeichnenden Notar Carlo WERSANDT, mit Amtssitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg);

SIND ERSCHIENEN:

1. Global Fin Tech Holding S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) ge-

gründet und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und
Gesellschaftsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) unter der Nummer B 184.665, mit Sitz in 7, avenue J.P.
Pescatore, L-2324 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg („Global Fin Tech Holding“),

Inhaber  von  zwölftausendvierhundertneunundneunzig  (12.499)  Stammanteilen  und  fünftausendzweihundertfünfzig

(5.250) Anteilen der Serie A,

hier vertreten durch Herrn Luis AGUERRE ENRÍQUEZ, Doctor en Derecho, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß

einer Vollmacht, vom 20. August, 2014, augestellt in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg;

2. Bambino 53. V V UG (haftungsbeschränkt), eine Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) bestehend unter

deutschem Recht, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland, unter der Nummer
HRB 126893 B, mit Sitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Deutschland („Bambino 53. V V“),

Inhaber eines (1) Stammanteils,
hier vertreten durch Herrn Luis AGUERRE ENRÍQUEZ, vorgenannt, gemäß einer Vollmacht vom 21. August 2014,

ausgestellt in Berlin, Deutschland;

3. HV Holtzbrinck Ventures Fund V GmbH &amp; Co. KG, eine Kommanditgesellschaft nach deutschem Recht mit sat-

zungsmäßigem Sitz in München, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München, Deutschland,

156020

L

U X E M B O U R G

unter der Nummer HRA 98863, mit Geschäftssitz in Kaiserstraße 14b, 80801 München, Deutschland, vertreten durch
ihren unbeschränkt haftenden Gesellschafter (general partner), HV Holtzbrinck Ventures Holding GmbH, eine Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung bestehend unter deutschem Recht, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts
München, Deutschland, unter der Nummer HRB 185098 B, mit Sitz in Kaiserstraße 14b, 80801 München, Deutschland
(„Holtzbrinck“),

Inhaber von dreitausendsechshundertfünfundzwanzig (3.625) Anteilen der Serie A, achthundertvierundvierzig (844)

Anteilen der Serie B und achthundertvierundfünfzig (854) Anteilen der Serie C,

hier vertreten durch Herrn Luis AGUERRE ENRÍQUEZ, vorgenannt, gemäß einer Vollmacht vom 21. August 2014,

ausgestellt in München, Deutschland;

4. Al Lendico Holdings LLC, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (limited liability company) nach dem Recht

des Bundesstaates Delaware, Vereinigte Staaten von Amerika, eingetragen beim Secretary of State des Bundesstaates
Delaware unter der Eintragungsnummer 5482207, mit satzungsmäßigem Sitz in 2711 Centerville Road, Suite 400, Wil-
mington, Delaware 19808, Vereinigte Staaten von Amerika („Access“),

Inhaber von dreitausendsechshundertfünfundzwanzig (3.625) Anteilen der Serie A, achthundertvierundvierzig (844)

Anteilen der Serie B und achthundertvierundfünfzig (854) Anteilen der Serie C,

hier vertreten durch Herrn Luis AGUERRE ENRÍQUEZ, vorgenannt, gemäß einer Vollmacht vom 20. August 2014,

ausgestellt in London, England;

5. TJT (B) (Bermuda) Investment Company Ltd., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (limited liability company)

nach dem Recht der Bermuda-Inseln, mit satzungsmäßigem Sitz in Hamilton, Bermuda, mit Geschäftssitz in Clarendon
House, 2 Church Street, Hamilton, Bermuda HM11 („TJT“),

Inhaber von vierhundert (400) Anteilen der Serie C,
hier vertreten durch Herrn Luis AGUERRE ENRÍQUEZ, vorgenannt, gemäß einer Vollmacht vom 22. August 2014,

ausgestellt in Bermuda;

6. Herr David W. Zalaznick, geboren am 16. April 1954 in New York, Vereinigte Staaten von Amerika, geschäftsansässig

in 9 West 57 

th

 Street - 33 

rd

 Floor, New York, NY 10019, USA („DZ“),

Inhaber von vierhundert (400) Anteilen der Serie C,
hier vertreten durch Herrn Luis AGUERRE ENRÍQUEZ, vorgenannt, gemäß einer Vollmacht vom 20. August 2014,

ausgestellt in New York, Vereinigte Staaten von Amerika;

7. Aismare Lux Holdings S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) gegründet

und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesell-
schaftsregister  (Registre  de  Commerce  et  des  Sociétés)  unter  der  Nummer  B  176.544,  mit  Sitz  in  6C,  rue  Gabriel
Lippmann, L-5365 Munsbach, Großherzogtum Luxemburg („Aismare“),

Inhaber von achthundert (800) Anteilen der Serie C,
hier vertreten durch Herrn Luis AGUERRE ENRÍQUEZ, vorgenannt, gemäß einer Vollmacht vom 22. August 2014,

ausgestellt in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg;

8. FEC Lux S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) gegründet und beste-

hend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister
(Registre de Commerce et des Sociétés) unter der Nummer B 173.487, mit Sitz in 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653
Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg („FEC“),

Inhaber von tausendneunhundertfünfundsiebzig (1.975) Anteilen der Serie C,
hier vertreten durch Herrn Luis AGUERRE ENRÍQUEZ, vorgenannt, gemäß einer Vollmacht vom 21. August 2014,

ausgestellt in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg; und

9. Bambino 110. V V UG (haftungsbeschränkt), eine Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) bestehend unter

deutschem Recht, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland, unter der Nummer
HRB 140400 B, mit Sitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Deutschland („Bambino 110. V V“),

zukünftiger Inhaber von achthundertzwanzig (820) Anteilen der Serie D und ausschließlich für die Punkte 4 ff. der

Tagesordnung teilnahmeberechtigt,

hier vertreten durch Herrn Luis AGUERRE ENRÍQUEZ, vorgenannt, gemäß einer Vollmacht vom 21. August 2014,

ausgestellt in Berlin, Deutschland.

Besagte Vollmachten, welche von dem Bevollmächtigten der erschienenen Parteien und dem Notar ne varietur para-

phiert wurden, werden der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.

Die unter Punkt 1 bis 8 aufgelisteten Parteien (die „Bestehenden Gesellschafter“) sind alle Gesellschafter und vertreten

das gesamte Gesellschaftskapital der ECommerce Holding II S.à r.l. (die „Gesellschaft”), einer Gesellschaft mit beschränk-
ter Haftung (société à responsabilité limitée), gegründet und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxem-
burg, mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels-
und  Gesellschaftsregister  unter  der  Nummer  B  177.435,  gegründet  am  7.  Mai  2013  gemäß  einer  Urkunde  des
unterzeichnenden Notars, welche am 10. Juli 2013 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1651
veröffentlicht wurde. Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt am 28. Juli 2014 gemäß einer Urkunde des unterzeichn-

156021

L

U X E M B O U R G

enden Notars geändert, welche noch nicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht wurde.
Die Satzung der Gesellschaft wurde seitdem nicht geändert.

Da die Bestehenden Gesellschafter das gesamte Gesellschaftskapital vertreten und erklären, auf jegliche Ladungsfor-

malitäten verzichtet zu haben, ist die Gesellschafterversammlung ordnungsgemäß zusammengekommen und kann wirksam
über alle Punkte der folgenden Tagesordnung verhandeln, wobei Bambino 110. V V ausschließlich für die Punkte 4 ff. der
folgenden Tagesordnung teilnahme- und stimmberechtigt ist:

<i>Tagesordnung

1. Beschluss bezüglich der Schaffung einer (1) weiteren Klasse von Anteilen, welche als Anteile der Serie D bezeichnet

werden (die „Anteile der Serie D“), mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1), wodurch nunmehr insgesamt
fünf (5) Anteilsklassen bestehen, aufgeteilt in Stammanteile, Anteile der Serie A, Anteile der Serie B, Anteile der Serie C
und Anteile der Serie D.

2. Aufnahme von Bambino 110. V V UG (haftungsbeschränkt), einer Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)

bestehend unter deutschem Recht, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland, unter
der Nummer  HRB 140400 B, mit  Sitz  in  Johannisstraße  20,  10117 Berlin,  Deutschland,  als neuer  Gesellschafter  der
Gesellschaft und Verzicht auf (i) Vorzugsrechte (preferential subscription rights) und (ii) Übertragungsbeschränkungen,
Bezugsrechte (preemptive rights), Vorkaufsrechte, Mitverkaufsrechte- und Pflichten oder andere Rechte der Bestehenden
Gesellschafter.

3. Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von einunddreißigtausendneun-

hunderteinundsiebzig Euro (EUR 31.971) um einen Betrag von achthundertzwanzig Euro (EUR 820) auf einen Betrag von
zweiunddreißigtausendsiebenhunderteinundneunzig Euro (EUR 32.791) durch die Ausgabe von achthundertzwanzig (820)
Anteilen der Serie D mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1).

4. Änderung und vollständige Neufassung der Satzung der Gesellschaft.
5. Genehmigung und, soweit erforderlich, Ratifizierung des Abschlusses und der Durchführung der Optionsvereinba-

rung (Option Agreement) durch die Gesellschaft.

6. Aufnahme von Joh. Berenberg, Gossler &amp; Co. KG, eines Finanzinstituts mit Geschäftssitz in Neuer Jungfernstieg 20,

20354 Hamburg, Deutschland, als neuer Gesellschafter der Gesellschafter, vorbehaltlich und mit der Ausübung einer
Option gemäß der Optionsvereinbarung (Option Agreement) und Verzicht auf (i) Vorzugsrechte (preferential subscrip-
tion rights) und (ii) Übertragungsbeschränkungen, Bezugsrechte (preemptive rights), Vorkaufsrechte, Mitverkaufsrechte-
und Pflichten oder andere Rechte der Bestehenden Gesellschafter.

Nach ordnungsgemäßer Prüfung jedes Tagesordnungspunkts fasst die Gesellschafterversammlung einstimmig die fol-

genden Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, eine (1) weitere Klasse von Anteilen zu schaffen, welche als Anteile der

Serie D bezeichnet werden (die „Anteile der Serie D“), mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1), wodurch
nunmehr insgesamt fünf (5) Anteilsklassen bestehen, aufgeteilt in Stammanteile, Anteile der Serie A, Anteile der Serie B,
Anteile der Serie C und Anteile der Serie D.

<i>Zweiter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung nimmt Bambino 110. V V UG (haftungsbeschränkt), eine Unternehmergesellschaft

(haftungsbeschränkt) bestehend unter deutschem Recht, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlotten-
burg, Deutschland, unter der Nummer HRB 140400 B, mit Sitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Deutschland, als neuen
Gesellschafter der Gesellschaft an. Die Gesellschafterversammlung nimmt den Verzicht der Bestehenden Gesellschafter
auf (i) deren Vorzugsrechte (preferential subscription rights) gemäß Artikel 5.3 der Satzung der Gesellschaft und (ii)
Übertragungsbeschränkungen, Bezugsrechte (preemptive rights), Vorkaufsrechte, Mitverkaufsrechte- und Pflichten oder
andere Rechte aus Gesellschaftervereinbarungen in Bezug auf die Gesellschaft zur Kenntnis, bei welchen die Bestehenden
Gesellschafter in Verbindung mit dieser außerordentlichen Gesellschafterversammlung Partei sind.

<i>Dritter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, das Gesellschaftskapital der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von

einunddreißigtausendneunhunderteinundsiebzig Euro (EUR 31.971) um einen Betrag von achthundertzwanzig Euro (EUR
820) auf einen Betrag von zweiunddreißigtausendsiebenhunderteinundneunzig Euro (EUR 32.791) durch die Ausgabe von
achthundertzwanzig (820) Anteilen der Serie D mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1), zu erhöhen.

<i>Zeichnung

Die achthundertzwanzig (820) neuen Anteile der Serie D wurden ordnungsgemäß von Bambino 110. V V, vorbenannt,

zu einem Preis von achthundertzwanzig Euro (EUR 820) gezeichnet.

156022

L

U X E M B O U R G

<i>Zahlung

Die von Bambino 110. V V, vorbenannt, gezeichneten achthundertzwanzig (820) Anteile der Serie D wurden vollständig

eingezahlt durch eine Bareinlage in Höhe von achthundertzwanzig Euro (EUR 820).

Der Nachweis über die Existenz und den Wert der oben bezeichneten Einlage wurde dem unterzeichnenden Notar

erbracht.

Die Einlage in Höhe von achthundertzwanzig Euro (EUR 820) wird vollständig dem Gesellschaftskapital zugeführt.

<i>Vierter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt die Änderung und vollständige Neufassung der Satzung der Gesellschaft und

nimmt zur Kenntnis, dass die Bestehenden Gesellschafter auf das vorherige Zustimmungserfordernis zur Änderung der
Satzung der Gesellschaft gemäß Artikel 22.8 der Satzung einstimmig verzichtet haben. Die Satzung der Gesellschaft lautet
nunmehr wie folgt:

„A. Name - Zweck - Dauer - Sitz

Art. 1. Name. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen

ECommerce Holding II S.à r.l. (die „Gesellschaft”), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über
Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Ge-

sellschaften, sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung
oder auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung,
Kontrolle und Entwicklung ihrer Beteiligungen.

2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder

Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören Garantien geben,
Sicherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.

2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere

durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und
Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheinen bzw. Wertpapieren.

2.4 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur, sowie

solche, welche geistiges Eigentum oder Grundeigentum betreffen, vornehmen, die ihr zur Erreichung dieser Zwecke
förderlich erscheinen, im Hinblick auf deren Verwertung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Art.

Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Die Gesellschaft kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung auf-

gelöst werden, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird.

Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Rates der Geschäftsführer

verlegt werden. Durch einen Gesellschafterbeschluss, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und
Weise gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer im

Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.

4.4 Sollte der Rat der Geschäftsführer entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale

Entwicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an
ihrem  Gesellschaftssitz  beeinträchtigen  könnten,  so  kann  der  Gesellschaftssitz  bis  zur  endgültigen  Beendigung  dieser
außergewöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben
keine Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes
eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt zweiunddreißigtausendsiebenhunderteinundneunzig Euro (EUR

32.791,00) mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1), bestehend aus

5.1.1 zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteilen (die „Stammanteile”),
5.1.2 zwölftausendfünfhundert (12.500) Anteilen der Serie A (die „Anteile der Serie A“),
5.1.3 eintausendsechshundertachtundachtzig (1.688) Anteilen der Serie B (die „Anteile der Serie B“),
5.1.4 fünftausendzweihundertdreiundachtzig (5.283) Anteilen der Serie C (die „Anteile der Serie C”), und

156023

L

U X E M B O U R G

5.1.5 achthundertzwanzig (820) Anteilen der Serie D (die „Anteile der Serie D“, wobei die Anteile der Serie A, die

Anteile der Serie B, die Anteile der Serie C und die Anteile der Serie D im Folgenden auch als „Vorzugsanteile“bezeichnet
werden).

Die mit den Anteilen verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es wird in dieser Satzung oder

durch das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.

5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-

zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.

5.3 (i) Global Fin Tech Holding S.à r.l. („Rocket“), (ii) HV Holtzbrinck Ventures Fund V GmbH &amp; Co. KG („Holtz-

brinck“), (iii) Al Lendico Holdings LLC („Access“), (iv) TJT (B) (Bermuda) Investment Company Ltd. (“TJT”), (v) David
W. Zalaznick („DZ“), (vi) Aismare Lux Holdings S.à r.l. („Aismare“), (vii) FEC Lux S.à r.l. („FEC“) und (viii) Joh. Berenberg,
Gossler &amp; Co. („Berenberg“), sofern und sobald dieser Gesellschafter der Gesellschaft wird (Rocket, Holtzbrinck, Access,
TJT, DZ, Aismare, FEC und Berenberg gemeinschaftlich die „Investoren“und jeweils ein „Investor“) ist zur Zeichnung
einer Anzahl weiterer bei einer Kapitalerhöhung ausgegebener Anteile berechtigt, wodurch ein Investmentangebot eines
Dritten umgesetzt wird (bei dem es sich weder um einen Gesellschafter, noch um eine mit einem Gesellschafter ver-
bundene Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG) (ein „Drittinvestor“) handelt), der mit
einer Mehrheit von mindestens fünfundsiebzig Prozent (75%) der Stimmen aller Gesellschafter der Gesellschaft zuge-
stimmt wurde (eine „Investition eines Dritten“) - unabhängig davon, ob diese vom Drittinvestor oder von einem oder
mehreren vergleichbaren Gesellschaftern erfolgte - und die zur Erhaltung der Beteiligungsquote an der Gesellschaft vor
einer solchen Kapitalerhöhung erforderlich ist, und dies zu denselben Bedingungen, wie bei einer Investition eines Dritten.
Der jeweilige Investor hat die Gesellschaft durch eine verbindliche Erklärung innerhalb von drei (3) Wochen darüber zu
unterrichten, ob er sein Recht gemäß des vorstehenden Satzes dieses Artikels 5.3 ausüben möchte, wobei die Investition
eines Dritten nach Ablauf dieser Frist (soweit nicht von den Investoren nach diesem Artikel 5.3 übernommen) durchge-
führt wird.

Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit jeweils dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht über-

schreiten darf.

6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs oder die Insol-

venz oder ein vergleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.

6.5 Die Gesellschaft kann Einlagen ohne Ausgabe von Anteilen oder anderen Sicherheiten als Gegenleistung annehmen

und diese einer oder mehreren ausschüttbaren Rücklagen zuführen. Entscheidungen bezüglich der Verwendung solcher
ausschüttbarer Rücklagen werden gegebenenfalls von dem(den) Gesellschafter(n) oder Geschäftsführer(n) unter Berück-
sichtigung des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung getroffen.

Art. 7. Anteilsregister - Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden

kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.

7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten

wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft
ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.

7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.
7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern, die

drei Viertel des Gesellschaftskapitals halten und vorbehaltlich der Bestimmungen von Gesellschaftervereinbarungen zwi-
schen den Gesellschaftern, sofern vorhanden, insbesondere vorbehaltlich Vorkaufsrechten, Bezugsrechten oder Mitver-
kaufsrechten- oder Pflichten aus Gesellschaftervereinbarungen zwischen den Gesellschaftern übertragen werden. Sofern
eine solche Zustimmung erteilt wurde, ist eine weitere Einwilligung zur Übertragung von Anteilen nicht erforderlich:

7.4.1 bei einer Übertragung, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen durch einen Investor an

eine mit dem betreffenden Investor verbundene Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG);

7.4.2 bei einem Verkauf, einer Übertragung, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen durch

einen Investor an eine Gesellschaft, (x) welche direkt oder indirekt (i) diesen Investor oder (ii) einen oder mehrere direkte
oder indirekte Gesellschafter des betreffenden Investors (jeweils eine „Kontrollierte Gesellschaft“) Kontrolliert, von
diesem Kontrolliert Wird, oder unter der gemeinsamen Kontrolle von diesem steht, wobei die Worte „Kontrolle“oder
„Kontrolliert Wird“oder „Kontrolliert“die direkte oder indirekte Beherrschung der Gesellschaft bezeichnet, durch (a)
die Leitung der Gesellschaft durch einen geschäftsführenden Gesellschafter, (b) das Halten der Mehrheit der Anteile oder
(c) das Halten der Mehrheit der Stimmrechte durch eine vertragliche Stimmvereinbarung, oder (d) die einseitige Fähigkeit,
direkt oder indirekt die Leitung der Geschäftsführung und Handlungsweisen einer Person, entweder durch das Halten

156024

L

U X E M B O U R G

stimmberechtigter Wertpapiere oder anderweitig, zu beeinflussen, oder (y) in welcher der betreffende Investor oder
einer oder mehrere Gesellschafter dieses Investors eine direkte oder indirekte Mehrheitsbeteiligung haben;

7.4.3  bei  einer  Übertragung,  einer  Abtretung  oder  einer  anderen  Veräußerung  von  Anteilen  (i)  an  einen  Dritten,

welcher  Anteile  unter  der  vereinfachten  Mitarbeiterbeteiligung  erwirbt,  oder  (ii)  an  die  Gesellschaft  und/oder  einen
beliebigen Investor gemäß einer Call-Option im Zusammenhang mit einer Vesting-Regelung;

7.4.4 bei einer Übertragung, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen im Rahmen von Um-

wandlungsvorgängen  gemäß  des  Umwandlungsrechts  Luxemburgs,  insbesondere  (jedoch  nicht  beschränkt  auf)  eine
Verschmelzung der Gesellschaft, sofern die Gesellschafter der Gesellschaft nach einem solchen Umwandlungsvorgang
mehr als fünfzig Prozent (50%) an einer überlebenden juristischen Person halten.

7.5 In den in Artikel 7.4.1 bis 7.4.4 vorgesehenen Fällen gelten weder Verpflichtungen zu Verkaufsangeboten, noch

Vorkaufsrechte, Bezugsrechte oder Mitverkaufsrechte- oder Pflichten zugunsten anderer Gesellschafter.

7.6 Eine Übertragung, eine Abtretung oder eine andere Veräußerung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft

und Dritten gemäß Artikel 1690 des Code Civil wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung, Abtretung oder
anderen Veräußerung in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung, Abtretung oder anderen Veräußerung zugestimmt
hat.

7.7 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters nur an neue Gesellschafter übertragen werden,

wenn Gesellschafter, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals (eine „Qualifizierte Mehrheit“) halten, einer
solchen Übertragung zustimmen (wobei die Anteile des verstorbenen Gesellschafters für diese Zwecke nicht berück-
sichtigt werden). Eine derartige Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn die Anteile an Eltern, Nachkommen oder den/
die überlebende/n Ehepartner/in oder jeden anderen gesetzlichen Erben des verstorbenen Gesellschafters übertragen
werden.

Art. 8. Liquidations- und Verkaufspräferenzen.
8.1  Im  Falle  (i)  eines  Verkaufs  von  mindestens  fünfzig  Prozent  (50%)  aller  Anteile  an  der  Gesellschaft  oder  eines

Tausches oder einer Übernahme der Gesellschaft in wirtschaftlich vergleichbarer Weise in einer oder einer Serie ver-
bundener Transaktionen oder in zeitlicher Nähe zueinander, oder (ii) der Liquidation der Gesellschaft oder (iii) eines
Verkaufs oder einer Übertragung von Anteilen an der Gesellschaft entweder an Dritte oder an andere Gesellschafter,
was dazu führen würde, dass entweder mehr als fünfzig Prozent (50%) des Gesellschaftskapitals oder mehr als fünfzig
Prozent (50%) der Stimmrechte im Besitz der erwerbenden Partei bzw. Parteien wären (change of control), als Ergebnis
eines oder mehrerer verbundener Akquisitionen, (wobei jeder der unter (i), (ii) und (iii) beschriebenen Fälle im Folgenden
als  „Liquiditätsereignis“bezeichnet  wird),  werden  die  Erlöse  („Exiterlöse“)  -vorbehaltlich  der  Artikel  8.2  bis  8.4  -  im
Einklang mit Artikel 8.5 auf einer pro rata-Basis entsprechend ihrer Beteiligung am Liquiditätsereignis an die Gesellschafter
verteilt.

8.2 Auf einer ersten Ebene („Erste Ebene”) erhalten die Inhaber von Anteilen der Serie C und von Anteilen der Serie

D einen Betrag, welcher dem Betrag ihrer jeweiligen Gesamtinvestition in die Gesellschaft entspricht (bestehend aus dem
Nominalbetrag der von diesem Inhaber erworbenen Anteile der Serie C oder ggf. Anteile der Serie D und dem Agio und/
oder anderen Kapitaleinlage (Konto 115 des Standardisierten Luxemburgischen Kontenplans), die von diesem Inhaber
(oder dem Vorgänger hinsichtlich der entsprechenden Anteile) an die Gesellschaft gezahlt wurden). Sind nicht ausreichend
Exiterlöse für die Zahlungen auf der Ersten Ebene vorhanden, so werden die Exiterlöse an die Inhaber der Anteile der
Serie C und der Anteile der Serie D auf einer pro-rata Basis zu den Beträgen verteilt, die an die Inhaber der Anteile der
Serie C und der Anteile der Serie D auf der Ersten Ebene verteilt worden wären, wenn ausreichend Exiterlöse vorhanden
gewesen wären.

8.3 Auf einer zweiten Ebene („Zweite Ebene”) erhalten die Inhaber von Anteilen der Serie B einen Betrag, welcher

dem Betrag ihrer jeweiligen Gesamtinvestition in die Gesellschaft entspricht (bestehend aus dem Nominalbetrag der von
diesem Inhaber erworbenen Anteile der Serie B und dem Agio und/oder anderen Kapitaleinlage (Konto 115 des Stan-
dardisierten Luxemburgischen Kontenplans), die von diesem Inhaber (oder dem Vorgänger hinsichtlich der entsprech-
enden Anteile) an die Gesellschaft gezahlt wurden). Sind nicht ausreichend Exiterlöse für die Zahlungen auf der Zweiten
Ebene vorhanden, so werden die Exiterlöse an die Inhaber der Anteile der Serie B auf einer pro-rata Basis zu den Beträgen
verteilt, die an die Inhaber der Anteile der Serie B auf der Zweiten Ebene verteilt worden wären, wenn ausreichend
Exiterlöse vorhanden gewesen wären.

8.4 Auf einer dritten Ebene („Dritte Ebene”) erhalten die Inhaber von Anteilen der Serie A einen Betrag, welcher dem

Betrag  ihrer  jeweiligen  Gesamtinvestition  in  die  Gesellschaft  entspricht  (bestehend  aus  dem  Nominalbetrag  der  von
diesem Inhaber erworbenen Anteile der Serie A und dem Agio und/oder anderen Kapitaleinlage (Konto 115 des Stan-
dardisierten Luxemburgischen Kontenplans), die von diesem Inhaber (oder dem Vorgänger hinsichtlich der entsprech-
enden  Anteile)  an  die  Gesellschaft  gezahlt  wurden).  Sind  nicht  ausreichend  Exiterlöse  für  die  Zahlungen  auf  der
Vorzugsebene vorhanden, so werden die Exiterlöse an die Inhaber der Anteile der Serie A auf einer pro-rata Basis zu
den Beträgen verteilt, die an die Inhaber der Anteile der Serie A auf der Vorzugsebene verteilt worden wären, wenn
ausreichend Exiterlöse vorhanden gewesen wären.

8.5 Nachdem die Zahlungen auf der Ersten, Zweiten und Dritten Ebene geleistet wurden, werden die übrigen Exiterlöse

auf einer gemeinsamen Ebene („Gemeinsame Ebene“) an alle Gesellschafter auf einer pro rata-Basis entsprechend ihrer
Beteiligung am Liquiditätsereignis verteilt. Sämtliche von einem Gesellschafter auf der Ersten, Zweiten und Dritten Ebene

156025

L

U X E M B O U R G

erhaltenen Beträge mindern den von diesem Gesellschafter zu erhaltenden Betrag auf der Gemeinsamen Ebene und
werden anschließend entsprechend dieser Gemeinsamen Ebene zugeteilt, mit der Maßgabe, dass kein Gesellschafter zur
Rückzahlung eines auf der Ersten, Zweiten und Dritten Ebene erhaltenen Betrags verpflichtet ist. Die Zuteilung auf der
Gemeinsamen Ebene erfolgt solange, bis alle Exiterlöse an die Gesellschafter verteilt wurden. Unabhängig davon, ob der
Verkauf von Anteilen während eines Liquiditätsereignisses oder danach in einer oder mehreren Transaktionen erfolgt
oder nicht, hat kein Gesellschafter für den Verkauf all seiner Anteile einen Betrag zu erhalten (und übersteigende Beträge
an die anderen Gesellschafter zurückzuzahlen), der höher ist, (i) als sein Anteil an der Gesamtheit der Exiterlöse oder
Erlöse auf einer pro rata-Basis zu den Anteilen, die auf einer gemeinsamen und gleichwertigen Basis verkauft wurden oder
(ii) als der Betrag, der diesem Gesellschafter auf der Ersten, Zweiten und Dritten Ebene aus einem späteren Verkauf
zugeteilt wurde. Sämtliche mit der hierin festgelegten Liquiditätspräferenz verbundenen Rechte können nur einmal aus-
geübt werden.

8.6 Die bevorzugte Zuteilung auf der Ersten, Zweiten und Dritten Ebene gilt für alle entsprechenden Vorzugsanteile

solange, wie bei den jeweiligen Vorzugsanteilen der jeweils in Artikel 8.2 bis Artikel 8.4 festgelegte Betrag noch nicht
verteilt wurde.

Art. 9. Rückkauf von Anteilen.
9.1 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen. Die Stimmrechte der von der Gesellschaft gehaltenen

Anteile werden so lange ausgesetzt, wie die Anteile von der Gesellschaft gehalten werden.

9.2 Anteile eines Gesellschafters können ohne Zustimmung eines solchen zurückgekauft werden, nur wenn:
9.2.1 ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des Gesellschafters eröffnet wird oder die Eröffnung eines Insolvenz-

verfahrens mangels Masse abgelehnt wird;

9.2.2 der Anteil des Gesellschafters gepfändet wurde oder Vollstreckungsverfahren anderweitig gegen diesen Anteil

eingeleitet wurden und diese Verfahren nicht innerhalb von zwei (2) Monaten vollständig eingestellt sind.

Mit Erhalt durch den Gesellschafter der vom Rat der Geschäftsführer gesendeten Rückkaufserklärung sind die Anteile

automatisch zurückgekauft, ohne dass es einer weiteren Handlung bedarf. Die vorliegende Satzung stellt gemeinsam mit
der Rückkaufserklärung ein gültiges Dokument im Sinne des Artikels 190 des Gesetzes von 1915 dar und die Gesellschaft
bestätigt hiermit die Kenntnisnahme der Übertragung der Anteile, akzeptiert diese und verpflichtet sich zur Eintragung
dieser Übertragung in ihrem Anteilsregister und zur entsprechenden gesetzlich geforderten Hinterlegung für diesen Fall.

9.3 Wird der Anteil von mehreren Personen gehalten, ist das Vorliegen eines Grundes zum Rückkauf in Bezug auf eine

Person ausreichend; unabhängig davon können mehrere gemeinschaftlich berechtigte Personen die Gesellschafterrechte
nur dann und einheitlich ausüben, wenn eine der gemeinschaftlich berechtigten Personen unverzüglich nach Eintritt der
gemeinschaftlichen Berechtigung zu diesem Zwecke ernannt wird.

9.4 Ein Rückkauf kann durch den Rat der Geschäftsführer erklärt werden. Die Rückkaufserklärung wird wirksam, sobald

der betreffende Gesellschafter die Erklärung erhält und ein entsprechender Gesellschafterbeschluss gefasst wird (außer
im Falle von Artikel 9.2 dieser Satzung, in welchem keine Erklärung des Gesellschafters und kein entsprechender Gesell-
schafterbeschluss erforderlich sind).

Art. 10. Ausgleichszahlung für den Rückkauf.
10.1 Der Rückkauf erfolgt gegen eine Ausgleichszahlung.
10.2 Die Ausgleichszahlung besteht aus einem Gesamtbetrag, welcher dem Marktwert der zurückgekauften Anteile

entspricht. Als Stichtag gilt der Tag vor dem Rückkaufsbeschluss.

10.3 Die Ausgleichszahlung für den Rückkauf ist unmittelbar mit dem Rückkauf der Anteile fällig und zahlbar.
10.4 Der ausscheidende Gesellschafter ist nicht dazu befugt, von der Gesellschaft Sicherheiten für ausstehende Beträge

zuzüglich Zinsen zu verlangen.

10.5 Bei Streitigkeiten hinsichtlich des Betrags der zu zahlenden Ausgleichszahlung für den Rückkauf ist diese Aus-

gleichszahlung von einem Wirtschaftsprüfer in der Eigenschaft als Schiedsgutachter, der von den Gesellschaftern gemein-
schaftlich ernannt wird, festzulegen. Wird über die Ernennung des Schiedsgutachters keine Einigung erzielt, so wird dieser
auf Ersuchen eines Gesellschafters oder der Gesellschaft vom Vorsitzenden des Bezirksgerichts (Tribunal d’Arrondisse-
ment) bestimmt. Die Entscheidung des Schiedsgutachters ist bindend. Die Kosten für das Gutachten werden von der
Gesellschaft und dem betreffenden Gesellschafter zu gleichen Teilen getragen, wobei der vom Gesellschafter zu tragende
Teil mit der Ausgleichszahlung für den Rückkauf verrechnet und die Ausgleichszahlung für den Rückkauf dementsprechend
herabgesetzt wird. Der Gesellschafter hat die übrigen Kosten zu tragen, sofern der Rückkaufspreis die dem Gesellschafter
zugewiesenen Kosten für das Gutachten nicht deckt.

Art. 11. Abtretung anstelle von Rückkauf.
11.1 Die Gesellschaft kann entscheiden, dass der betreffende Gesellschafter anstelle des Rückkaufs die Anteile an eine

von der Gesellschaft benannte Person (einschließlich eines anderen Gesellschafters) zu übertragen hat, auch im Falle eines
Teilrückkaufs oder einer Teilabtretung der Anteile an die Gesellschaft oder an eine von der Gesellschaft benannte Person,
vorbehaltlich der Artikel 189 und 190 des Gesetzes von 1915.

156026

L

U X E M B O U R G

11.2 Der vorliegende Artikel 11 gilt mit der Maßgabe, dass, wie in Artikel 10 dieser Satzung vorgesehen, die Aus-

gleichszahlung  für  die  abzutretenden  Anteile  durch  die  die  Anteile  erwerbende  Person  geschuldet  ist  und  dass  die
Gesellschaft als Garant für diese Summe haftet.

C. Entscheidungen der Gesellschafter

Art. 12. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
12.1 Die Gesellschafterversammlung ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch das Gesetz und diese Satzung

ausdrücklich vorbehalten sind.

12.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.
12.3  Falls  und  solange  die  Gesellschaft  nicht  mehr  als  fünfundzwanzig  (25)  Gesellschafter  hat,  dürfen  gemeinsame

Entscheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung vorbehalten wären, schriftlich gefasst werden. In die-
sem Fall erhält jeder Gesellschafter den Text der zu fassenden Beschlüsse oder Entscheidungen in ausformulierter Form
und übt sein Stimmrecht schriftlich aus.

12.4 Gesellschafterbeschlüsse werden in Versammlungen gefasst. Sofern nicht zwingende gesetzliche Vorschriften eine

andere Form vorschreiben, können sie auch außerhalb von Versammlungen in schriftlicher Form (einschließlich E-Mail
oder Fax) oder durch telefonische Abstimmung gefasst werden, sofern ein solches Verfahren von einem Gesellschafter
ersucht wird und kein anderer Gesellschafter innerhalb von zwei (2) Wochen in schriftlicher Form Widerspruch gegen
dieses Verfahren gegenüber dem Rat der Geschäftsführer der Gesellschaft einlegt. Wird innerhalb von zwei (2) Wochen
kein Widerspruch gemäß des vorstehenden Satzes eingelegt, so werden die Stimmen der nicht an der Abstimmung teil-
nehmenden Gesellschafter als Enthaltungen gewertet. Schriftliche Beschlüsse sind von jedem Gesellschafter zu unter-
zeichnen und die Niederschrift ist jedem Gesellschafter unverzüglich zuzusenden. Beschlüsse, welche nicht in schriftlicher
Form gefasst werden, sind schriftlich zu bestätigen. Eine solche Bestätigung hat ausschließlich feststellende Bedeutung.

12.5 Von jedem Beschluss, der in Gesellschafterversammlungen gefasst wurde, ist unverzüglich eine Niederschrift

anzufertigen (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die Wirksamkeit), die das Datum und die Form des gefassten
Beschlusses, den Inhalt des Beschlusses und die abgegebenen Stimmen zu enthalten hat, es sei denn, die Gesellschafter-
beschlüsse wurden notariell beurkundet. Die Niederschrift muss jedem Gesellschafter unverzüglich in schriftlicher Form
zugesendet werden.

12.6 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschriften

des  Abschnitts  XII  des  Gesetzes  von  1915  und  dieser  Satzung  aus.  In  diesem  Fall  ist  jede  Bezugnahme  auf  die
„Gesellschafterversammlung“in der vorliegenden Satzung als Bezugnahme auf den Alleingesellschafter, je nach Zusam-
menhang und soweit anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Allein-
gesellschafter ausgeübt.

Art. 13. Gesellschafterversammlung.
13.1 Gesellschafterversammlungen finden am Sitz der Gesellschaft oder an einem Ort und zu einer Zeit statt, welche

in der entsprechenden Einladung genauer bestimmt werden.

13.2  Die  Gesellschafterversammlung  wird  mittels  Einschreiben  (Zustellung  zu  eigenen  Händen,  Einschreiben  oder

Einschreiben mit Rückschein) an jeden Gesellschafter einberufen und beinhaltet den Ort, das Datum, die Uhrzeit und die
Tagesordnung,  wobei  bei  ordentlichen  Gesellschafterversammlungen  eine  Ankündigungsfrist  von  mindestens  vier  (4)
Wochen und bei außerordentlichen Gesellschafterversammlungen eine Ankündigungsfrist von mindestens zwei (2) Wo-
chen einzuhalten ist. Die Ankündigungsfrist beginnt am Tag nach dem Versand. Der Tag der Gesellschafterversammlung
wird bei der Berechnung der Ankündigungsfrist nicht berücksichtigt.

13.3 Falls alle Gesellschafter in einer Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten sind und auf Einladungs-

formalitäten verzichtet haben, kann die Versammlung auch ohne vorherige Ankündigung abgehalten werden.

13.4  Jeder  Gesellschafter  ist  dazu  berechtigt,  bei  der  Gesellschafterversammlung  von  einem  anderen  durch  eine

schriftliche Vollmacht dazu berechtigten Gesellschafter oder von einem Anwalt, Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer
unter der Berufsverschwiegenheitspflicht begleitet oder vertreten zu werden.

13.5 Eine Niederschrift hinsichtlich des Ablaufs der Versammlung ist (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die

Wirksamkeit) anzufertigen und hat den Ort und das Datum der Versammlung, die Teilnehmer, die Tagesordnungspunkte,
den Hauptinhalt der Verhandlungen und die Gesellschafterbeschlüsse zu beinhalten, es sei denn, die Verhandlungen der
Gesellschafterversammlung wurden notariell beurkundet. Die Niederschrift ist von allen bei der Gesellschafterversamm-
lung  anwesenden  oder  vertretenen  Gesellschaftern  zu  unterzeichnen  (als  Nachweis,  nicht  als  Voraussetzung  für  die
Wirksamkeit). Jedem Gesellschafter ist eine Kopie der Niederschrift zuzusenden.

Art. 14. Quorum und Abstimmung.
14.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.
14.2 Eine Gesellschafterversammlung ist nur dann beschlussfähig, wenn mindestens fünfzig Prozent (50%) des Gesell-

schaftskapitals vertreten sind. Vorbehaltlich anderer Regelungen dieser Satzung oder des Gesetzes von 1915, die ein
höheres Mehrheitsverhältnis vorsehen, bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von
Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals innehaben. Bei Beschlussunfähigkeit ist unverzüglich im
Einklang mit Artikel 13.2 eine neue Gesellschafterversammlung mit derselben Tagesordnung einzuberufen. Diese Gesell-

156027

L

U X E M B O U R G

schafterversammlung ist dann unabhängig von dem vertretenen Gesellschaftskapital beschlussfähig, sofern darauf in der
die Versammlung einberufenden Ladung hingewiesen wurde und Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen
Stimmen gefasst.

Art. 15. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.

Art. 16. Änderung der Satzung.  Eine  Änderung  dieser  Satzung  erfordert  die  Zustimmung  (i)  einer  zahlenmäßigen

Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die gleichzeitig eine Qualifizierte Mehrheit darstellen.

Art. 17. Beschlüsse, die eine spezifische Mehrheit erfordern.
17.1 Gesellschafterbeschlüsse hinsichtlich der folgenden Angelegenheiten erfordern eine Qualifizierte Mehrheit:
17.1.1 Veräußerung des gesamten Gesellschaftsvermögens oder eines beträchtlichen Anteils des Gesellschaftsvermö-

gens einschließlich des Beschlusses hinsichtlich der Liquidation der Gesellschaft;

17.1.2 Beschluss hinsichtlich der Verschmelzung, Ausgliederung und Umwandlung der Gesellschaft;
17.1.3 Abschluss von Unternehmensverträgen (im Sinne der §§ 291 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG));
17.1.4 Abschluss von Unternehmensbeteiligungen (um Zweifel auszuschließen, nicht durch die Veräußerung von An-

teilen) jeglicher Art einschließlich stiller Beteiligungen und sämtlicher Verträge, durch welche die andere Vertragspartei
eine Beteiligung am Gewinn der Gesellschaft erhält oder jede Zahlung, welche vom Gewinnbetrag der Gesellschaft ab-
hängig ist; dies umfasst nicht Verträge mit Gesellschaftern oder Angestellten der Gesellschaft, einschließlich Verträge,
welche im Hinblick auf einen voraussichtlichen Status als Gesellschafter oder Angestellter abgeschlossen wurden, sowie
Verträge mit Dritten innerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs, z.B. Verträge zwischen der Gesellschaft und Werbe-
partnern.

17.2 Beschlüsse hinsichtlich der folgenden Angelegenheiten erfordern eine Qualifizierte Mehrheit und zudem die vor-

herige Zustimmung der Investoren.

17.2.1 Ausschluss von Bezugsrechten im Falle von Kapitalerhöhungen;
17.2.2 Erwerb eigener Anteile der Gesellschaft, mit Ausnahme der Erwerbe gemäß Artikel 9.2 und Übertragungen

gemäß Artikel 11.1 dieser Satzung.

17.3  Ist  das  Gesellschaftskapital  in  verschiedene  Anteilsklassen  unterteilt,  so  können  die  spezifischen  Rechte  und

Pflichten im Zusammenhang mit einer Anteilsklasse mit der einstimmigen und schriftlichen Zustimmung der Gesellschaf-
ter, die alle ausgegebenen Anteile dieser Anteilsklasse halten, verändert oder aufgehoben werden.

D. Rat der Geschäftsführer - Beirat

Art. 18. Befugnisse des Alleinigen Geschäftsführers - Zusammensetzung und Befugnisse des Rates der Geschäftsführer.
18.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Ge-

schäftsführer hat, bilden diese einen Rat der Geschäftsführer.

18.2  Falls  die  Gesellschaft  von  einem  einzelnen  Geschäftsführer  geleitet  wird  und  soweit  der  Begriff  „alleiniger

Geschäftsführer“nicht ausdrücklich in dieser Satzung verwendet wird, ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Rat
der Geschäftsführer“als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer“auszulegen.

18.3 Der Rat der Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, im Namen der Gesellschaft zu handeln

und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.

Art. 19. Ernennung, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
19.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung ernannt, welche ihre Bezüge und

ihre Amtszeit festlegt.

19.2 Die Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund ernannt oder abberufen werden.
19.3 Die Gesellschafterversammlung kann die Ernennung von Geschäftsführern zwei (2) unterschiedlicher Kategorien

beschließen, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Eine solche Klassifizierung
der Geschäftsführer muss ordnungsgemäß in der Niederschrift des betreffenden Gesellschafterbeschlusses festgehalten
und die Geschäftsführer der Kategorie, der sie angehören, zugeordnet werden.

Art. 20. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
20.1  Scheidet  ein  Geschäftsführer  durch  Tod,  Geschäftsunfähigkeit,  Insolvenz,  Rücktritt  oder  aus  einem  anderem

Grund aus seinem Amt aus, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen
die ursprüngliche Amtszeit des ersetzten Geschäftsführers nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesell-
schafterversammlung ausgefüllt werden, welche im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die
endgültige Ernennung entscheidet.

20.2  Für  den  Fall,  dass  der  alleinige  Geschäftsführer aus  seinem Amt  ausscheidet, muss die  frei gewordene  Stelle

unverzüglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.

156028

L

U X E M B O U R G

Art. 21. Einladung zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
21.1 Der Rat der Geschäftsführer versammelt sich auf Einberufung durch einen Geschäftsführer. Die Sitzungen des

Rates der Geschäftsführer finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.

21.2  Die  Geschäftsführer  werden  mindestens  vierundzwanzig  (24)  Stunden  vor  dem  für  die  Sitzung  anberaumten

Zeitpunkt zu jeder Sitzung des Rates der Geschäftsführer schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe
der Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Geschäftsführer
per Post, Fax, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abgegeben haben, wobei
eine Kopie eines solchen Dokuments ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung zu Sitzungen des Rates der Ge-
schäftsführer ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss des Rates der Geschäftsführer
bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.

21.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle

Einladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Rates
der Geschäftsführer diesen zustimmen und diese unterzeichnen.

Art. 22. Geschäftsführung.
22.1 Der Rat der Geschäftsführer kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Rat der Ge-

schäftsführer kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise selbst ein Geschäftsführer sein muss
und der für die Protokollführung der Sitzungen des Rates der Geschäftsführer verantwortlich ist.

22.2 Sitzungen des Rates der Geschäftsführer werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Rates der Ge-

schäftsführer geleitet. In dessen Abwesenheit kann der Rat der Geschäftsführer einen anderen Geschäftsführer durch
einen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Mitglieder als Vorsitzenden pro tempore ernennen.

22.3 Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer teilnehmen, indem er einen anderen

Geschäftsführer schriftlich oder durch Faxschreiben, per E-Mail oder durch ein anderes vergleichbares Kommunikati-
onsmittel bevollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Geschäftsführer
kann einen oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.

22.4 Eine Sitzung des Rates der Geschäftsführer kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein

anderes Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu
hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel
ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung gilt als am Sitz der Ge-
sellschaft abgehalten.

22.5 Der Rat der Geschäftsführer kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest eine Mehrheit der

Geschäftsführer in einer Sitzung anwesend oder vertreten ist.

22.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Rates der Geschäftsführer

teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden,
hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme. Sofern die Gesellschafterversammlung allerdings un-
terschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäfts-
führer der Kategorie B), werden Beschlüsse des Rates der Geschäftsführer nur dann wirksam gefasst, wenn sie von der
Mehrheit der Geschäftsführer einschließlich mindestens eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsfüh-
rers der Kategorie B (oder deren Vertreter) gefasst werden.

22.7 Der Rat der Geschäftsführer kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung,

per Faxschreiben, oder per E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Jeder Geschäftsführer
kann  seine  Zustimmung  getrennt  erteilen,  wobei  die  Gesamtheit  aller  schriftlichen  Zustimmungen  die  Annahme  des
betreffenden Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Be-
schlusses.

22.8 Die Geschäftsführer benötigen die Zustimmung von mindestens zwei (2) der Gesellschafter Rocket, Holtzbrinck,

Access, TJT, DZ, Aismare, FEC und Berenberg (sofern Berenberg zum gegebenen Zeitpunkt ein Inhaber von Anteilen
ist), die zum gegebenen Zeitpunkt gemeinsam mehr als fünfzig Prozent (50%) des eingetragenen Gesellschaftskapitals der
Gesellschaft halten (die „Mehrheit der Investoren“) für die unten genannten Rechtsgeschäfte und Maßnahmen. Eine Zu-
stimmung ist nicht erforderlich, sofern solche Rechtsgeschäfte und Maßnahmen präzise definiert und im Voraus von einem
bewilligten Haushaltsplan mit der Zustimmung der Mehrheit der Investoren genehmigt wurden:

22.8.1 Gründung, Erwerb, Schließung oder Veräußerung von Unternehmen oder Teilbetrieben;
22.8.2 Änderung der Statuten, dieser Satzung, Gesellschaftervereinbarungen und ähnlicher Verträge, sowie die Aus-

übung (oder der Ausschluss) von Gesellschafterrechten bei Gesellschaften, in denen eine Beteiligung gehalten wird;

22.8.3 Erwerb, Verkauf und Belastung von Immobilien und ähnlichen Rechten oder Rechten an Immobilien;
22.8.4 Gründung, Verlegung und Schließung von Filialen und Niederlassungen;
22.8.5 Änderung der Geschäftsfelder der Gesellschaft und Aufgabe bestehender und Aufnahme neuer Geschäftsfelder;
22.8.6 Genehmigung des Jahresplans, insbesondere des Haushaltsplans für jedes folgende Jahr;
22.8.7 Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder ähnlichen Verpflichtungen, die einen Gesamtbetrag von zwei-

hunderttausend Euro (EUR 200.000,00) überschreiten;

156029

L

U X E M B O U R G

22.8.8  Gewährung  von  Darlehen,  die,  im  Einzelfall,  einen  Betrag  von  zweihunderttausend  Euro  (EUR  200.000,00)

überschreiten, allerdings unter Ausschluss von Darlehen zwischen der Gesellschaft und direkten oder indirekten Toch-
tergesellschaften der Gesellschaft;

22.8.9 Abschluss und Kündigung von Kredit- und Darlehensverträgen und anderen Finanzverträgen, die, im Einzelfall,

einen Betrag von zweihunderttausend Euro (EUR 200.000,00) überschreiten und Änderungen des Kreditrahmens und
außerordentliche Rückzahlungen, allerdings unter Ausschluss von Verträgen zwischen der Gesellschaft und direkten oder
indirekten Tochtergesellschaften der Gesellschaft;

22.8.10 Termingeschäfte über Devisen, Sicherheiten und börsengehandelte Waren und Rechte, sowie weitere Trans-

aktionen mit derivaten Finanzinstrumenten;

22.8.11 Gewährung, Einführung und Änderung von Versorgungsverpflichtungen jeglicher Art;
22.8.12 Abschluss, Änderung und Auflösung von Arbeitsverträgen, die eine Vergütung von einhundertfünfzigtausend

Euro (EUR 150.000,00) pro Jahr überschreiten;

22.8.13 Zusicherung oder Gewährung von Sonderzulagen und Gratifikationen jeglicher Art außerhalb bestehender

Arbeitsverträge, sowie Zahlung von Vorschüssen oder Gewährung von Darlehen an Geschäftsführer und Angestellte,
die, im Einzelfall, einen Betrag von fünfzigtausend Euro (EUR 50.000,00) überschreiten;

22.8.14 Abschluss, Änderung oder Kündigung von Unternehmenstarifverträgen, Betriebsvereinbarungen (von erheb-

licher Bedeutung) und allgemeiner Richtlinien hinsichtlich der betrieblichen Altersvorsorge der Gesellschaft;

22.8.15 Einleitung oder Beendigung von Rechtsstreitigkeiten, insbesondere Schiedsgerichtverfahren mit einem Streit-

wert von über zehntausend Euro (EUR 10.000,00) im Einzelfall;

22.8.16 Erwerb, Verfügung und/oder Lizenzierung von Nutzungsrechten jeglicher Art hinsichtlich der Rechte an geist-

igem Eigentum, einschließlich Urheberrechte oder sämtliche weiteren Schutzrechte, sowie die Weitergabe von Know-
how zur eigenen Verwertung durch die Firma und/oder Drittparteien, sowie die Erteilung oder der Erwerb von Lizenzen
und die Abänderung diesbezüglicher Verträge, jedoch unter Ausschluss von Verfügungen zwischen der Gesellschaft und
direkten und indirekten Tochtergesellschaften der Gesellschaft;

22.8.17 Erteilung einer Vollmacht, durch welche ein Bevollmächtigter einen anderen Bevollmächtigten dazu ermächtigt,

auf Kosten der Gesellschaft einen Vertrag mit diesem zu schließen;

22.8.18 Transaktionen der Gesellschaft und ihrer Investoren mit verbundenen juristischen und natürlichen Personen.

Als  solche  werden  angesehen  direkte  oder  indirekte  Gesellschafter  der  Gesellschaft  (einschließlich,  zur  Klarstellung,
European Founders Fund GmbH („EFF“) und EFF’s direkte und indirekte Gesellschafter (z.B. die Samwer Brüder), aber
ausschließlich direkter oder indirekter Gesellschafter von Holtzbrinck und/oder Access und/oder TJT und/oder DZ und/
oder Aismare und/oder FEC und/oder Berenberg (sofern Berenberg zum gegebenen Zeitpunkt ein Inhaber von Anteilen
ist)), verbundene Gesellschaften gemäß §§ 15 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG), sowie Angehörige direkter oder
indirekter Gesellschafter gemäß Abschnitt 15 der deutschen Abgabenordnung (AO), sofern letztere (mit Ausnahme von
EFF und EFF’s direkten und indirekten Gesellschaftern) - einzeln oder gemeinsam - direkt oder indirekt eine Mehrheits-
beteiligung  halten.  Die  Zustimmung  gemäß  dieses  Artikels  22.8.18  ist  nicht  erforderlich,  wenn  die  Transaktion  zum
gewöhnlichen Geschäftsgang der Gesellschaft gehört und marktüblichen Bedingungen unterliegt;

22.8.19 Änderung der Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft;
22.8.20 Gewährung, Schaffung oder Änderung eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms (einschließlich der Gewährung

jeglicher Aktienoptionen) außerhalb der bestehenden vereinfachten Mitarbeiterbeteiligung, die zwischen den Gesellschaf-
tern in einer Gesellschaftervereinbarung vereinbart wurde;

22.8.21 Ausübung von Stimmrechten und anderen Rechten in einer Gesellschaft, deren Gesellschafter die Gesellschaft

ist, sofern diese Ausübung, wenn die Gesellschaft betroffen wäre, die Zustimmung der Mehrheit der Investoren nach
dieser Satzung erfordern würde, d.h. gemäß dieses Artikels 22.8 oder Artikels 17.

22.9 Ist die Zustimmung zum Erwerb, zum Verkauf oder zur Belastung von Objekten wie oben beschrieben erforder-

lich, so ist die Zustimmung ebenfalls für die damit verbundenen vertraglichen Verpflichtungen erforderlich. Die Gesell-
schafterversammlung kann durch einen Beschluss weitere Transaktionen und Maßnahmen bestimmen, die die Zustimmung
der Mehrheit der Investoren erfordern. Die Mehrheit der Investoren kann ihre Zustimmung für bestimmte Gruppen und
Arten von Transaktionen und Maßnahmen auch im Voraus erteilen.

22.10 Die Gesellschafter können durch einen Gesellschafterbeschluss eine Geschäftsordnung für die Geschäftsführer

beschließen.

22.11 Die Geschäftsführung hat sicherzustellen, dass die Bestimmungen dieses Artikels 22, soweit gesetzlich möglich,

auf die gleiche Weise auf sämtliche verbundenen Gesellschaften angewendet werden, in welchen die Gesellschaft direkt
oder indirekt gegenwärtig oder künftig eine Mehrheitsbeteiligung hält.

Art. 23. Protokoll von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer; Protokoll der Entscheidungen des Alleinigen Ge-

schäftsführers.

23.1 Das Protokoll einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer wird vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer,

falls vorhanden oder, im Falle seiner Abwesenheit, vom Vorsitzenden pro tempore und dem Schriftführer (falls vorhan-
den), oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unterschied-

156030

L

U X E M B O U R G

liche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der
Kategorie B), werden Protokolle von einem (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einem (1) Geschäftsführer der
Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsver-
fahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer, falls
vorhanden, oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden solche Kopien oder Auszüge von einem (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einem (1)
Geschäftsführer der Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet.

23.2 Die Entscheidungen des alleinigen Geschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom alleinigen

Geschäftsführer unterzeichnet wird. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet.

Art. 24. Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Um-

ständen  (i)  durch  die  Unterschrift  des  alleinigen  Geschäftsführers  oder,  für  den  Fall,  dass  die  Gesellschaft  mehrere
Geschäftsführer hat, durch die gemeinsamen Unterschriften zwei (2) beliebiger Geschäftsführer wirksam verpflichtet;
sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäfts-
führer  der  Kategorie  A  und  Geschäftsführer  der  Kategorie  B),  wird  die  Gesellschaft  nur  durch  die  gemeinsamen
Unterschriften mindestens eines (1) Geschäftsführers der Kategorie A und eines (1) Geschäftsführers der Kategorie B
(oder deren Vertreter), oder (ii) durch die gemeinsamen Unterschriften oder die alleinige Unterschrift jedweder Person
(en), der/denen eine Unterschriftsbefugnis durch den Rat der Geschäftsführer übertragen worden ist, wirksam verpflich-
tet.

Art. 25. Beirat.
25.1 Die Gesellschaft hat einen Beirat. Die Gesellschafterversammlung kann durch einen einstimmigen Gesellschaf-

terbeschluss die Anzahl der stimmberechtigten Mitglieder des Beirats erhöhen oder herabsetzen, vorausgesetzt, dass
Rocket nicht dazu berechtigt ist, mehr als vier (4) stimmberechtigte Mitglieder zu ernennen, es sei denn, Rocket erhöht
seinen Anteilsbesitz an der Gesellschaft.

25.2 Die Gesellschafterversammlung kann die Geschäftsordnung für den Beirat nur durch einen einstimmigen Gesell-

schafterbeschluss festlegen und/oder verändern.

25.3 Die stimmberechtigten Mitglieder des Beirats werden von dem ernennenden Gesellschafter jedes entsprechenden

Mitglieds durch schriftliche Mitteilung an die Gesellschaft wie folgt ernannt, abberufen oder ersetzt:

25.3.1 Vier (4) stimmberechtigte Mitglieder des Beirats werden von dem Gesellschafter Rocket nach eigenem Ermessen

ernannt;

25.3.2 Ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats wird von dem Gesellschafter Holtzbrinck nach eigenem Ermessen

ernannt;

25.3.3 Ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats wird von dem Gesellschafter Access nach eigenem Ermessen

ernannt;

25.3.4 Ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats wird von dem Gesellschafter Aismare nach eigenem Ermessen

ernannt; und 25.3.5 Ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats wird von dem Gesellschafter FEC nach eigenem Er-
messen ernannt.

25.4 Der Beirat hat stimmberechtigte und nicht-stimmberechtigte Mitglieder als Beobachter.
25.5 Der Beirat hat einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden. Ein von Rocket ernanntes stimm-

berechtigtes  Mitglied  ist  der  Vorsitzende  des  Beirats.  Die  Geschäftsordnung  des  Beirats  hat  weitere  Bestimmungen,
insbesondere  hinsichtlich  der  Selbstorganisation  des  Beirats,  zu  enthalten.  Der  Beirat  fasst  Beschlüsse  mit  einfacher
Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Der Beirat hält regelmäßig Sitzungen ab, mindestens einmal pro Kalenderquartal.

25.6 Der Beirat ist für die Beratung der Geschäftsführer der Gesellschaft hinsichtlich Strategie und operativer Ange-

legenheiten zuständig und berät mit den Geschäftsführern über den Haushalt der Gesellschaft.

25.7 Der Beirat ist kein Aufsichtsrat im Sinne des Artikels 60bis-11 ff. des Gesetzes von 1915.

E. Aufsicht und Prüfung der gesellschaft

Art. 26. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
26.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der

Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)). Die Gesellschafterversammlung
ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.

26.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
26.3 Die Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Recht der permanenten Überprüfung und Kontrolle aller Ge-

schäfte der Gesellschaft.

26.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember

2002  betreffend  das  Handelsregister  und  die  Buchhaltung  und  den  Jahresabschluss  von  Unternehmen,  in  der  jeweils

156031

L

U X E M B O U R G

gültigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d’entreprises agréé(s)) ernennen, entfällt
die Funktion des Rechnungsprüfers.

26.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die

Gesellschafterversammlung abberufen werden.

F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinnverwendung - Abschlagsdividenden

Art. 27. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am

einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

Art. 28. Jahresabschluss und Gewinne.
28.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Rat der Geschäftsführer erstellt im

Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und
Verlustrechnung.

28.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage

der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.

28.3  Durch  einen  Gesellschafter  erbrachte  Einlagen  in  Rücklagen  können  mit  Zustimmung  dieses  Gesellschafters

ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.

28.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage der Gesellschaft verhältnis-

mäßig herabgesetzt werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.

28.5 Auf Vorschlag des Rates der Geschäftsführer bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den Be-

stimmungen des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung, wie der verbleibende jährliche Nettogewinn der Gesellschaft
verwendet werden soll.

28.6 Vorbehaltlich des Artikels 8 erfolgen Ausschüttungen an die Gesellschafter proportional zur Anzahl der von ihnen

an der Gesellschaft gehaltenen Anteile.

Art. 29. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
29.1 Der Rat der Geschäftsführer kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche

vom Rat der Geschäftsführer vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur
Verfügung stehen. Der ausschüttbare Betrag wird gegebenenfalls im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 8 und
des Artikels 28.6 verteilt und darf nicht die Summe der seit dem Ende des vergangenen Geschäftsjahres angefallenen
Gewinne, gegebenenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne und ausschüttbare Rücklagen, beziehungsweise vermindert
durch vorgetragene Verluste und Summen, die einer Rücklage zugeführt werden, welche nach dem Gesetz von 1915 oder
dieser Satzung nicht ausgeschüttet werden darf, übersteigen.

29.2 Das Agio, andere Kapitalreserven oder andere ausschüttbare Rücklagen können im Einklang mit den Bestimmun-

gen des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

G. Liquidation

Art. 30. Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Liqui-

dation durch einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden,
die über die Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit
nichts anderes bestimmt wird, haben die Liquidatoren die weitestgehenden Befugnisse für die Verwertung der Vermö-
genswerte und die Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

H. Schlussbestimmungen - Anwendbares recht

Art. 31. Anwendbares Recht.
31.1 Sämtliche in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten unterliegen den Bestimmungen des Gesetzes von

1915 und jeder Gesellschaftervereinbarung, die die Gesellschafter mitunter mit der Gesellschaft eingehen und durch die
bestimmte Bestimmungen dieser Satzung ergänzt werden könnten. Sollte ein Artikel dieser Satzung mit den Bestimmungen
einer Gesellschaftervereinbarung in Widerspruch stehen, so ist die Gesellschaftervereinbarung zwischen den Parteien,
soweit nach luxemburgischem Recht zulässig, maßgebend.

31.2 Diese Satzung wurde auf Englisch verfasst, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; im Falle von Abweichungen

zwischen der englischen und der deutschen Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.“

<i>Fünfter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung genehmigt und, soweit erforderlich, ratifiziert den Abschluss und die Durchführung

der  Optionsvereinbarung  (Option  Agreement),  welche  zwischen  der  Gesellschaft,  den  Bestehenden  Gesellschaftern,
Bambino 110 und Joh. Berenberg, Gossler &amp; Co. KG, einem Finanzinstitut mit Geschäftssitz in Neuer Jungfernstieg 20,
20354 Hamburg, Deutschland, („Berenberg“) am oder um den 28. August 2014 eingegangen wurde (die „Optionsver-
einbarung“).

156032

L

U X E M B O U R G

<i>Sechster Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, Berenberg vorbehaltlich und bei Ausübung einer Option, welche Berenberg

gemäß der Optionsvereinbarung gewährt wird, als neuen Gesellschafter der Gesellschaft anzunehmen. Die Gesellschaf-
terversammlung nimmt den Verzicht der Bestehenden Gesellschafter auf (i) deren Vorzugsrechte (preferential subscrip-
tion  rights)  gemäß  Artikel  5.3  der  Satzung  der  Gesellschaft  und  (ii)  Übertragungsbeschränkungen,  Bezugsrechte
(preemptive rights), Vorkaufsrechte, Mitverkaufsrechte- und Pflichten oder andere Rechte aus Gesellschaftervereinba-
rungen in Bezug auf die Gesellschaft zur Kenntnis, bei welchen die Bestehenden Gesellschafter in Verbindung mit dieser
außerordentlichen Gesellschafterversammlung Partei sind.

Da die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung geschlossen.

<i>Kosten und Auslagen

Die Kosten, Auslagen, Honorare und Gebühren jeglicher Art, die von der Gesellschaft zu tragen sind, werden auf

ungefähr tausendachthundert Euro (EUR 1.800,-) geschätzt.

<i>Erklärung

Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache beherrscht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende

Urkunde auf Verlangen der erschienenen Parteien auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung;
auf Verlangen besagter erschienener Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen
Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.

WORÜBER die vorliegende notarielle Urkunde in Luxembourg, an dem oben angegebenen Tag, erstellt wurde.
Nach Vorlesung der vorliegenden Urkunde an den Bevollmächtigten der erschienenen Parteien, handelnd wie zuvor

erwähnt, dem Notar mit Vor- und Zunamen, Personenstand und Wohnort bekannt, hat besagte Bevollmächtigte mit Uns,
dem Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: L. AGUERRE ENRIQUEZ, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 septembre 2014. LAC/2014/40799. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 29 septembre 2014.

Référence de publication: 2014152032/1388.
(140173650) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2014.

A.F.I.L. S.à r.l., Agence Fonseca Immobilier Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 191, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 59.638.

L'an deux mille quatorze, le vingt-neuf septembre
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1) Monsieur Antonio José DA FONSECA, agent immobilier, né à Resende (Portugal) le 19 mai 1968, demeurant à

L-3521 Dudelange, 37, rue Karl Marx,

agissant en son nom personnel et en tant que mandataire spécial de:
2) Madame Maria Celina DE JESUS CARDOSO, auxiliaire, née à Sao Sebastiao Da Pedreira (Portugal) le 12 mai 1970,

demeurant à L-3521 Dudelange, 37, rue Karl Marx,

en vertu d'une procuration sous seing privé délivrée à lui.
Ladite procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le comparant agissant en sa dite qualité et le notaire

instrumentaire demeurera annexée aux présentes pour être soumises ensemble aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants déclarent être les associés de la société à responsabilité limitée «AGENCE FONSECA IMMO-

BILIER LUXEMBOURG», en abrégé «A.F.I.L. S.à r.l.», établie et ayant son siège social à L-3850 Schifflange, 72-80, Avenue
de la Libération, société constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Gérard LECUIT, notaire alors de résidence à
Hesperange, en date du 29 mai 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 517 du 23 septembre
1997, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 59638.

Ensuite les comparants, agissant en leurs dites qualités, représentant l’intégralité du capital social, ont pris à l’unanimité

la résolution suivante:

156033

L

U X E M B O U R G

<i>Résolution unique

Les associés décident de transférer le siège social de la société de L-3850 Schifflange, 72-80, Avenue de la Libération

à L-1941 Luxembourg, 191, Route de Longwy, et de modifier en conséquence le premier alinéa de l’article 3 des statuts
pour lui donner la teneur suivante:

«Le siège social est établi à Luxembourg.».
Les autres alinéas de l’article 3 restent inchangés.

<i>Frais

Les frais, dépenses, charges et rémunérations en relation avec les présentes sont tous à charge de la société.
Plus rien d'autre ne se trouvant à l’ordre du jour, les comparants ont déclaré close la présente assemblée.

DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, il a signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: DA FONSECA, MOUTRIER.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 01/10/2014. Relation: EAC/2014/13146. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): HALSDORF.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 02/10/2014.

Référence de publication: 2014151894/42.
(140173938) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2014.

ICG International Computing Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 101.522.

L’an deux mille quatorze, le seizième jour du mois de septembre;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

soussigné;

Se réunie

l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l’“Assemblée”) de la société anonyme régie par les lois du Grand-

Duché de Luxembourg “ICG International Computing Group S.A.”, établie et ayant son siège social à L-1140 Luxembourg,
45-47, route d'Arlon, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro
101522, (la “Société”), constituée suivant acte reçu par Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage (Grand-
Duché de Luxembourg), en date du 28 juin 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
877 du 30 août 2004,

et dont les statuts (les “Statuts”) n'ont plus été modifiés depuis lors.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Regina ROCHA MELANDA, employée, demeurant profession-

nellement à L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

La Présidente désigne Madame Nathalie MAGER, employée, demeurant professionnellement à L-1140 Luxembourg,

45-47, route d'Arlon, comme secrétaire.

L'Assemblée choisit Madame Monika HECK, employée, demeurant professionnellement à L-1140 Luxembourg, 45-47,

route d'Arlon, comme scrutatrice.

Le bureau ayant ainsi été constitué, la Présidente expose et prie le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
A) Que la présente Assemblée a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Dissolution de la Société et décision de mettre la Société en liquidation volontaire;
2. Décharge accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société pour l’exercice de leurs

mandats respectifs;

3. Nomination de la société “Benoy Kartheiser Management S.à r.l.”, en abrégé “BKM”, en tant que liquidateur en vue

de la liquidation volontaire de la Société;

4. Détermination des pouvoirs du Liquidateur et détermination de la procédure de mise en liquidation de la Société;
5. Nomination d'un commissaire-vérificateur;
6. Divers.

156034

L

U X E M B O U R G

B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux, sont

portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux
représentés, les membres du bureau de l’Assemblée et le notaire instrumentant.

C) Que les procurations des associés représentés, signées “ne varietur” par les membres du bureau de l’Assemblée

et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.

D) Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés,

déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l’ordre du jour préalablement à cette Assemblée et
renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.

E) Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement sur les objets portés à l’ordre du jour.

Ensuite, l’Assemblée aborde l’ordre du jour, et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes.

<i>Première résolution

L'Assemblée décide avec effet immédiat de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation volontaire.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée  décide  d'accorder  décharge  aux  administrateurs  et  au  commissaire  aux  comptes  de  la  Société  pour

l’exercice de leurs mandats respectifs jusqu'à la date des présentes.

L’Assemblée décide de reconnaître, approuver, ratifier et reprendre au compte de la Société tous les actes pris par

les administrateurs de la Société pour la période débutant à la date de constitution de la Société et se terminant à ce jour
et de renoncer à son droit d’exercer tout recours à l’encontre des administrateurs résultant de leur gestion de la Société.

<i>Troisième résolution

L'Assemblée décide de nommer la société à responsabilité limitée “Benoy Kartheiser Management S.à r.l.”, en abrégé

“BKM”, établie et ayant son siège social à L-1140 Luxembourg, 47, route d'Arlon, inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 33849, en tant que liquidateur (le “Liquidateur”) de la Société.

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée décide de conférer au Liquidateur les pouvoirs les plus étendus, prévus par les articles 144 et suivants

de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée (la “Loi”).

L'Assemblée décide également d'instruire le Liquidateur, dans la limite de ses capacités et selon les circonstances, afin

qu'il réalise l’ensemble des actifs et solde les dettes de la Société.

L'Assemblée décide que le Liquidateur sera autorisé à signer tous actes et effectuer toutes opérations au nom de la

Société, y compris les actes et opérations stipulés dans l’article 145 de la Loi, sans autorisation préalable de l’assemblée
générale des actionnaires. Le Liquidateur pourra déléguer ses pouvoirs pour des opérations spécifiques ou d'autres tâches
à une ou plusieurs personnes ou entités, tout en conservant seul la responsabilité des opérations et tâches ainsi déléguées.

L'Assemblée décide également de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur, pour le compte de la Société en liqui-

dation, afin qu'il exécute, délivre, et effectue toutes obligations relatives à tout contrat ou document requis pour la
liquidation de la Société et à la liquidation de ses actifs.

L'Assemblée décide en outre de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur afin d'effectuer, à sa discrétion, tous

versements d'avances en numéraire ou en nature des boni de liquidation aux actionnaires de la Société, conformément
à l’article 148 de la Loi.

La Société, en liquidation, est valablement et sans limitation engagée envers des tiers par la signature du Liquidateur,

pour tous les actes y compris ceux impliquant tout fonctionnaire public ou notaire.

<i>Cinquième résolution

Conformément à l’article 151 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales l’Assemblée

décide de nommer Monsieur Jeannot DIDERRICH, expert-comptable, né à Ettelbruck (Grand-Duché de Luxembourg),
le 27 mars 1973, demeurant professionnellement à L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon, aux fonctions de com-
missaire-vérificateur à la gestion de la liquidation.

Aucun autre point n'étant porté à l’ordre du jour de l’Assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés

ne demandant la parole, la Présidente a ensuite clôturé l’Assemblée.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états civils et domiciles, lesdits

comparants ont signé ensemble avec Nous notaire le présent acte.

Signé: R. ROCHA MELANDA, N. MAGER, M. HECK, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 19 septembre 2014 LAC/2014/43566. Reçu douze euros 12,00 €.

<i>Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

156035

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 29 septembre 2014.

Référence de publication: 2014151610/90.
(140172900) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2014.

Sensata Investment Company S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1748 Luxembourg, 4, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 114.729.

In the year two thousand fourteen, on the tenth day of September,
Before the undersigned, Maître Henri Hellinckx, notary resident in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

was held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of Sensata Investment Company S.C.A, a corporate

partnership limited by shares (société en commandite par actions) existing and organised under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg, having its registered office at 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, Grand-Duchy of
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 114.729 (the Company).

The Company was incorporated deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, dated 8 February

2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Mémorial) number 1027 on May 26, 2006.
The articles of association of the Company have been amended several times and for the last time on July 17, 2014
pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, not yet published in the Mémorial.

The Meeting is chaired by Régis Galiotto, notary’s clerk, with professional address in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary and the Meeting elected as scrutineer, Solange Wolter, notary’s clerk, with

professional address in Luxembourg.

The Meeting’s officers having thus been appointed, the chairperson declares and requests the notary to state that:
I. the limited shareholders (actionnaires commanditaires) and the general partner (associé commandité) of the Com-

pany (collectively referred to as the Shareholders) are present or represented and the number of their shares are shown
on an attendance list. Such list signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, shall remain
attached to the present minutes;

II. as it appears from the attendance list that all the shares are represented. The Meeting is thus regularly constituted

and may deliberate and decide on the items on the agenda of which the participants have been beforehand informed;

III. the agenda of the Meeting is as follows:
1. Waiver of the convening notices;
2. Dissolution of the Company;
3. Appointment of the liquidator;
4. Powers of the liquidator;
5. Instructions for the liquidator; and
6. Any other business.
IV. That the Meeting has unanimously taken the following resolutions:

<i>First resolution

The entirety of the share capital being represented at the present Meeting, the Shareholders waive the convening

notices, acknowledging being sufficiently informed of the agenda which has been made available to them in advance.

<i>Second resolution

The Shareholders resolve to dissolve the Company with immediate effect and to put it into liquidation (liquidation

volontaire).

<i>Third resolution

The Shareholders resolve to appoint Sensata Management Company S.A., a public limited liability company (société

anonyme) existing and organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 4, rue
Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under
number B 114.569 as the Company’s liquidator (the Liquidator). The Liquidator is empowered, by its sole signature, to
do whatever is required for the liquidation of the Company and the disposal of its assets.

<i>Fourth resolution

The Shareholders resolve to grant the Liquidator all the powers set out in articles 144 et seq. of the Luxembourg law

of 10 August, 1915 on commercial companies, as amended (the Law).

156036

L

U X E M B O U R G

The Liquidator is entitled to execute all deeds and carry out all operations, including those referred to in article 145

of the Law, without the prior authorisation of the Shareholders. The Liquidator may, on its sole responsibility, delegate
some of its powers to one or more persons or entities for specifically defined operations or tasks.

The Liquidator is authorised to make advance payments of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the Sha-

reholders, subject to the drawing-up of interim accounts.

<i>Fifth resolution

The Shareholders resolve to instruct the Liquidator to realise all the Company’s assets on the best possible terms and

to pay all its debts.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with this

notarial deed are estimated at approximately one thousand five hundred Euro (EUR 1,500.-).

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the Shareholders, this deed

is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of discrepancies, the English text prevails.

This notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the date stated above.
After reading this deed aloud, the notary signs it with the Meeting’s officers and the Shareholders’ authorised repre-

sentative.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatorze, le dixième jour de septembre.
Par-devant nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

S'est tenue

une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) des actionnairess de Sensata Investment Company S.C.A., une

société en commandite par actions constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social
est établi au 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 114.729 (la Société).

La Société a été constituée suivant un acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, le 8 février

2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le Mémorial), n°1027 du 26 mai 2006. Les statuts de
la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois le 17 juillet, 2014 suivant un acte de Maître Henri
Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg en cours de publication au Mémorial.

L’Assemblée est présidée par Régis Galiotto, clerc de notaire, de résidence professionnelle à Luxembourg.
Le président nomme comme secrétaire et l’Assemblée choisit Solange Wolter, clerc de notaire, de résidence profes-

sionnelle à Luxembourg comme scrutateur.

Le Bureau ayant ainsi été constitué, le président déclare et demande au notaire d’acter que:
I. les actionnaires commanditaires et l’associé commandité (collectivement désignés les Actionnaires) de la Société

sont présents ou représentés et le nombre des actions qu’ils détiennent est indiqué sur une liste de présence. Ladite liste
signée ne varietur par les parties comparantes et le notaire instrumentant restera attaché au présent procès-verbal;

II. tel qu’il apparaît sur la liste de présence, l’intégralité des actions est représentée. L’Assemblée est par conséquent

valablement constituée et peut délibérer et décider sur les points de l’ordre du jour auxquels les participants ont pré-
alablement eu connaissance;

III. l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Dissolution de la Société;
3. Nomination du liquidateur;
4. Pouvoirs du liquidateur;
5. Instructions données au liquidateur; et
6. Divers.
IV. Que l’Assemblée a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’intégralité du capital social étant représentée lors de la présente Assemblée, les Actionnaires décident de renoncer

aux formalités de convocation, déclarant avoir une parfaite connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué
au préalable.

156037

L

U X E M B O U R G

<i>Deuxième résolution

Les Actionnaires décident de dissoudre la Société avec effet immédiat et de la placer en liquidation volontaire.

<i>Troisième résolution

Les Actionnaires décident de nommer Sensata Management Company S.A., une société anonyme constituée et régie

selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social est établi au 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-
Findel, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 114.569 en tant
que liquidateur de la Société (le Liquidateur). Le Liquidateur est autorisé à accomplir tout ce qui est nécessaire à la
liquidation de la Société et à la réalisation des actifs de la Société sous sa seule signature.

<i>Quatrième résolution

Les Actionnaires décident d’attribuer au Liquidateur tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi

luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi).

Le Liquidateur est autorisé à passer tous les actes et à exécuter toutes les opérations, en ce compris les actes prévus

à l’article 145 de la Loi, sans l’autorisation préalable des Actionnaires. Le Liquidateur pourra déléguer, sous sa seule
responsabilité, certains de ses pouvoirs, pour des opérations ou tâches spécifiquement définies, à une ou plusieurs per-
sonnes physiques ou morales.

Le Liquidateur est autorisé à verser des acomptes sur le boni de liquidation aux Actionnaires de la Société, sous réserve

de l’établissement de comptes intérimaires.

<i>Cinquième résolution

Les Actionnaires décident de confier au Liquidateur la mission de réaliser, dans les meilleures conditions, tous les actifs

de la Société, et de payer toutes les dettes de la Société.

<i>Estimation des frais

Les dépenses, frais et rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui pourraient incomber à la Société

à la suite du présent acte sont estimés à environ mille cinq cents Euros (EUR 1.500.-).

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate, qu’à la requête des Actionnaires, le présent acte est

rédigé en anglais suivi d’une traduction française et qu’en cas de divergence entre la version anglaise et la version française,
la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite par le notaire, ce dernier signe le présent acte avec les membres du Bureau.
Signé: R. GALIOTTO, S. WOLTER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 19 septembre 2014. Relation: LAC/2014/43647. Reçu douze euros (12.- EUR).

<i>Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 29 septembre 2014.

Référence de publication: 2014151765/136.
(140173363) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2014.

Anoa Capital S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 155.833.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-fourth day of September.
Before Maître Joëlle Baden, civil notary, residing in Luxembourg,

There appeared:

Maître Philippe Harles, avocat, professionally residing in Luxembourg,
acting as the representative of the board of directors of Anoa Capital S.A., a société anonyme incorporated and existing

under the laws of Luxembourg, having its registered office at L-2132 Luxembourg, 2-4, Avenue Marie-Thérèse, registered
with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 155.833 (the “Company”),

pursuant to a power of attorney given on 19 

th

 respectively 22 

nd

 September 2014.

The appearing person, acting in said capacity, has requested the undersigned notary to state the declarations as follows:
1) The Company has been incorporated pursuant to a notarial deed dated 28 September 2010 of the undersigned

notary, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2456 dated 13 November 2010. The

156038

L

U X E M B O U R G

articles of incorporation of the Company have been amended for the last time pursuant to a notarial deed dated 18 July
2013 of the undersigned notary, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2418 dated
1 October 2013.

2) The subscribed share capital of the Company was set at one million euro (EUR 1,000,000), represented by one

hundred and fifty thousand (150,000) shares without designation of a nominal value.

3) Pursuant to article 5 of the articles of incorporation, the authorised capital, excluding the current issued share

capital, is set at five million Euro (EUR 5,000,000). During a period of five (5) years from the date of the publication of
the shareholders’ resolution creating the authorised share capital in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
or, as the case may be, of the resolution to renew or to increase the authorised share capital pursuant to article 5, the
board of directors is authorised to issue shares and to issue any other instruments convertible into shares within the
limits of the authorised share capital to such persons and on such terms as they shall see fit and specifically to proceed
to such issue and issues of shares upon conversion of any convertible bonds without reserving a preferential right to
subscribe to the shares issued for the existing shareholders, other than to the extent such a preferential subscription
right is reserved to the shareholders under the terms of a shareholders’ agreement, if any, or the articles of incorporation
of the Company.

4) On 12 September 2014, the board of directors of the Company has decided to increase, within the limits of the

authorised capital, the share capital by an amount of one million three hundred thousand euro (EUR 1,300,000) without
issuing new shares and by way of incorporation of retained earnings.

5) As a consequence of such increase of share capital, the article 5 (1) of the articles of incorporation is amended and

shall henceforth read as follows:

” Art. 5. Share capital.
(1) The Company has a share capital of two million three hundred thousand Euros (EUR 2,300,000) divided into one

hundred and fifty thousand (150,000) shares without designation of a nominal value.”

Whereupon the present deed is drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, at the date named

at the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing person

the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person and in case
of divergences between the English text and the French text, the English text will prevail.

After reading and interpretation to the appearing person, said appearing person signed together with the notary the

present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le vingt-quatre septembre,
Par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

Maître Philippe Harles, avocat, demeurant professionnellement au Luxembourg,
agissant en sa qualité de représentant du conseil d’administration de Anoa Capital S.A., une société anonyme, ayant

son siège social à L-2132 Luxembourg, 2-4, Avenue Marie-Thérèse, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 155.833 (la «Société»),

conformément à une procuration donnée en date du 19 respectivement 22 septembre 2014.
Le comparant, agissant en la qualité mentionnée ci-dessus, a demandé au notaire instrumentant de documenter les

déclarations suivantes:

1) La Société a été constituée par un acte du notaire soussigné du 28 septembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil

des Sociétés et Associations, numéro 2456 en date du 13 novembre 2010. Les statuts de la Société ont été modifiés pour
la dernière fois suivant acte du notaire soussigné en date du 18 juillet 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 2418 en date du 1 

er

 octobre 2013.

2) Le capital souscrit de la Société est fixé à un million d’euros (EUR 1.000.000), représenté par cent cinquante mille

(150.000) actions sans mention de la valeur nominale.

3) Selon l’article 5 des statuts de la Société, le capital autorisé, en ce non compris le capital social souscrit, s’élève à

un montant de cinq millions d’euros (EUR 5.000.000). Pendant une période cinq (5) ans à partir de la date de publication
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, de la résolution des actionnaires créant un capital social autorisé,
ou, le cas échéant, de la résolution tendant à renouveler ou à augmenter le capital social autorisé en vertu de l’article 5,
le conseil d’administration est autorisé à émettre des actions et tout autre titre convertible en actions dans les limites du
capital social autorisé, aux personnes et selon les conditions qu'il juge appropriées, et notamment à procéder à une telle
émission lors de la conversion de toute obligation convertible sans réserver le droit préférentiel de souscription des
actionnaires existants de souscrire les nouvelles actions à émettre, sauf dans la mesure où ce droit préférentiel de sou-
scription est réservé aux actionnaires en vertu des statuts ou, le cas échéant, d’un pacte d’actionnaire.

156039

L

U X E M B O U R G

4) Le 12 septembre 2014, le conseil d’administration de la Société a décidé d’augmenter, dans les limites du capital

autorisé, le capital social d’un montant de un million trois cents mille euros (EUR 1.300.000) sans émission d’actions et
par intégration des bénéfices reportés.

5) Suite à l’augmentation du capital, l’article 5 (1) des statuts de la Société sont modifiés et ont désormais la teneur

suivante:

« Art. 5. Capital social.
(1) La Société a un capital social de deux millions trois cents mille euros (EUR 2.300.000) divisé en cent cinquante mille

(150.000) actions sans mention de la valeur nominale.»

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. HARLES et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 26 septembre 2014. LAC / 2014 / 44683. Reçu soixante quinze euros € 75,-.

<i>Le Receveur ff.

 (signé): FRISING.

- POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 6 octobre 2014.

Référence de publication: 2014151903/92.
(140173879) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2014.

AOF3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 154.246.

DISSOLUTION

In the year two thousand and fourteen, on the fourteenth day of August,
before Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains (Grand Duchy of Luxembourg),

there appeared:

AnaCap Debt Opportunities Limited, a non-cellular company limited by shares with registered office at PO Box 60,

Carinthia House, 9-12 The Grange, St. Peter Port, Guernsey, Channel Islands, registered at the Guernsey Registry under
number 51048,

hereby represented by Ms Magdalena Staniczek, lawyer, professionally residing at 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Lu-

xembourg,

by virtue of a proxy under private seal given on August 12, 2014, which, after having been signed ne varietur by the

proxyhlder of the appearing party and the undersigned notary, will be annexed to these minutes.

Such appearing party, represented as mentioned above, has requested the undersigned notary to state that:
I. AOF 3 S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) organized and existing under the

laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with a share capital of GBP 15,000.-, having its registered office at 6, rue Gabriel
Lippmann, L-5365 Munsbach, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 154.246,
was incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, on 12 July 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Memorial"), number
1698 of 20 August 2010 and its articles were amended for the last time by deed of Me Edouard Delosch, notary residing
in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg, dated 29 October 2012 and published in the Memorial number 2886 dated 28
November 2012 (the "Company");

II. The capital of the Company is fixed at fifteen thousand British pounds sterling (GBP 15,000.-), divided into twelve-

thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one pound sterling and twenty pence (GBP 1.20) each, all
of which are fully paid up.

III. The appearing party is the sole shareholder of the Company.
IV. That the appearing party has decided to dissolve the Company with immediate effect as the activity of the Company

has ceased.

V. In its capacity as sole shareholder of the Company and to the extent necessary, liquidator of the Company, and

based on the interim accounts of the Company as at 8 August 2014 established by the board of managers and approved
through this document by the Company's sole shareholder, the appearing party declares that the Company has no con-
tractual guarantees and if such obligations come to light at a later time that it will assume such guarantees of the Company;

156040

L

U X E M B O U R G

VI. It declares, for the avoidance of doubt, to take over all assets of the Company to the extent the Company holds

any such assets.

VII. It resolves to waive its right to appoint an auditor to the liquidation in charge of reporting on the liquidation

operations carried out by the Company’s liquidator and thus declares that there is no need to hold a second general
meeting and resolves to hold immediately the third and last general meeting.

VIII. It agrees to assume on behalf and in the name of the Company, all possible liabilities currently unknown to the

Company and/or not entirely paid to the date hereof;

IX. As a result of the above, the liquidation of the Company is to be considered closed and that any registers of the

Company recording the issuance of shares or any other securities shall be cancelled;

X. Full discharge is granted to Ms Audrey Lewis, Mr Malcolm Lindsay Wilson and Mr Hugo Neumann, being the

managers of the Company, for the exercise of their mandates except than in cases of gross negligence or wilful misconduct;

XI. The books and documents of the Company shall be kept during a period of five years at 6, rue Gabriel Lippmann,

L-5365 Munsbach.

<i>Costs

The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it

by reason of the present deed are estimated approximately at two thousand euro (EUR 2,000.-).

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states that on request of the proxyholder of the ap-

pearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between
the English and the French texts, the English version will be binding.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the said proxyholder signed together with

the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le quatorzième jour d'août,
par-devant Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains (Grand-Duché de Luxembourg),

a comparu:

AnaCap Debt Opportunities Limited, une non-cellular company limited by shares, ayant son siege social au PO Box

60, Carinthia House, 9-12 The Grange, St. Peter Port, Guernsey, Îles de la Manche, enregistrée auprès du Guernsey
Registry sous le numéro 51048,

ici représentée par Madame Magdalena Staniczek, avocat, demeurant professionnellement à 2, rue Jean Bertholet,

L-1233 Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 12 août 2014, qui, après avoir été signée ne varietur par le

mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, sera annexée au présent acte.

Laquelle comparante, représentée comme mentionné ci-dessus, a requis le notaire soussigné d'acter que:
I. AOF 3 S.à r.l., une société à responsabilité limitée organisée sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant un

capital social de GBP 15.000,-, qui a son siège social à 6, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, enregistrée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 154.246, a été constituée par acte de Maître
Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 12 juillet 2010, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial") sous le numéro 1698 du 20 août 2010 et ses statuts ont été
modifiés la dernière fois par un acte de Me Edouard Delosch, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxem-
bourg, le 29 octobre 2012 et publié au Mémorial numéro 2886 du 28 novembre 2012 (la "Société").

II. Le capital social de la Société est fixé à quinze mille livres sterling (GBP 15.000,-) divisé en douze mille cinq cents

(12.500) parts sociales d'une valeur nominale d'une livre sterling et vingt centimes de livres sterling (GBP 1,20) chacune.
Toutes parts sociales ont été entièrement libérées.

III. La partie comparante est l’associé unique de la Société.
IV. La partie comparante a décidé de dissoudre la Société, avec effet immédiat, étant donné que la Société a cessé

toute activité.

V. En sa capacité d'associé unique de la Société et, en tant que besoin, en tant que liquidateur de la Société, et sur base

des comptes intérimaires de la Société en date du 8 août 2014 dressés par le conseil de gérance de la Société et approuvés
par la présente par l’associé unique de la Société, la partie comparante déclare que tous les garanties de la Société à l’égard
de  tiers  ont  été  entièrement  réglées  ou  prises  en  charge  et  si  des  telles  obligations  seront  découvertes  à  une  date
ultérieure, elle va assumer ces garanties de la Société.

VI. La partie comparante déclare, pour éviter toute ambiguïté, de reprendre tous les actifs de la Société dans la mesure

où la Société détient des actifs.

156041

L

U X E M B O U R G

VII. La partie comparante décide de renoncer son droit de nommer un commissaire à la liquidation chargé de la

liquidation effectuée par le liquidateur de la Société et déclare en conséquence qu'il n'y a aucun besoin de tenir une
deuxième assemblée et décide de tenir immédiatement la troisième et dernière assemblée.

VIII. Elle accepte d'assumer au nom et pour le compte de la Société, tout passif actuellement inconnu par la Société

et/ou demeurant pas entièrement payée à la date des présentes.

IX. En conséquence de ce qui précède, la liquidation de la Société est à considérer comme clôturée et que tout registre

de la Société comportant l’inscription de l’émission des parts sociales ou des autres titres sera annulé.

X. Une décharge pleine et entière est accordée à Mme Audrey Lewis, M Malcolm Lindsay Wilson, et M Hugo Neumann,

étant les gérants de la Société, pour l’exercice de leurs mandats sauf en cas de négligence grosse ou faute intentionnelle.

XI. Les livres et documents de la Société seront conservés pendant une durée de cinq ans à 6, rue Gabriel Lippmann,

L-5365 Munsbach.

<i>Coûts

Les frais, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui devront être supportés par la Société à la suite de cet acte

notarié sont estimés approximativement à deux mille euros (EUR 2.000,-).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire instrumentant qui parle et comprend l’anglais déclare qu'à la demande du mandataire de la comparante, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française et qu'en cas de divergence entre le texte anglais et français,
la version anglaise prévaudra.

Le document ayant été lu au mandataire de la comparante, lequel est connu du notaire par son nom, prénom, état

civil, adresse, ledit mandataire a signé, ensemble avec le notaire, cet acte authentique.

Signé: M. Staniczek, M. Loesch.
Enregistré à Remich, le 20 août 2014. REM/2014/1803. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): P. MOLLING.

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 1 

er

 octobre 2014.

Référence de publication: 2014151906/116.
(140173620) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2014.

Biminvest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 95.821.

L'an deux mille quatorze, le vingt-deux septembre,
par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg,

s'est réunie

l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "BIMINVEST S.A." (la «Société»), ayant

son siège social à L-1746 Luxembourg, 1, Rue Joseph Hackin, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg, sous le numéro B 95.821, constituée suivant acte notarié en date du 11 septembre 2003, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1.073 du 15 octobre 2003. Les statuts ont été modifiés pour la dernière
fois suivant acte notarié du 5 novembre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 269
du 25 mars 2005.

L'assemblée est ouverte à 15.00 heures sous la présidence de Madame Sara PUTTEMANS, employée privée, L-1746

Luxembourg, 1, Rue Joseph Hackin,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Olivier DE PINIEUX, employé privé, L-1746 Luxembourg, 1, Rue Joseph

Hackin.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Isabelle BASTIN, employée privée, L-1746 Luxembourg, 1, Rue Joseph

Hackin.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Suppression de la désignation de la valeur nominale des actions
2. Modification du nombre d’actions représentant le capital social afin de porter le nombre d’actions de 1.000 actions

à 3.600 actions.

3. Modification subséquente de l’article 5 des statuts de la Société.

156042

L

U X E M B O U R G

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Après délibération, l’assemblée générale prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions figurant dans les statuts de

la Société.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de modifier le nombre d’actions représentant le capital social afin de porter le nombre

d’actions de mille (1.000) actions à trois mille six cents (3.600) actions. En conséquence, les mille (1.000) actions existantes
sont annulées et remplacées par les trois mille six cents (3.600) actions nouvelles attribuées aux actionnaires existants
en proportion de leur participation dans le capital social.

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l’article 5 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:
«Le capital social de la société est fixé à la somme de cent mille euros (EUR 100.000,-) représenté par trois mille six

cents (3.600) actions sans désignation de valeur nominale.

Chaque action donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.»

<i>Frais

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toute sorte qui incombent à la société du fait du présent acte s'élèvent

approximativement à mille cinq cents euros (EUR 1.500.-).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire instrumentant,

le présent acte.

Signé: S. PUTTEMANS, O. DE PINIEUX, I. BASTIN et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 septembre 2014. LAC / 2014 / 44240. Reçu soixante quinze euros. 75,-

<i>Le Receveur ff. (signé): FRISING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 6 octobre 2014.

Référence de publication: 2014151938/65.
(140173880) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2014.

Caballo Fello S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3333 Hellange, 53, route de Bettembourg.

R.C.S. Luxembourg B 150.183.

L'an deux mille quatorze, le douze septembre.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1) Monsieur Claude LOSCH, indépendant, né à Luxembourg le 17 décembre 1961, demeurant à L-6922 Berg, 10, rue

du Château, associé et gérant détenant 50 parts sociales dans la société ci-après spécifiée.

2) Madame Nadia FELIGIONI, employée privée, époux de Monsieur Luc Guy FRINGS, née à Esch-sur-Alzette le 1 

er

mars 1968, demeurant à L-4398 Pontpierre, 5, am Armschlag, associée détenant 50 parts sociales dans la société ci-après
spécifiée.

Lesquels comparants déclarent être les seuls associés de la société à responsabilité limitée «Caballo Fello S.à r.l.»,

établie et ayant son siège social à L-4210 Esch-sur-Alzette, 58, rue de la Libération, société constituée aux termes d'un

156043

L

U X E M B O U R G

acte reçu par Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg en date du 8 décembre 2009, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 164 du 26 janvier 2010, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
à Luxembourg sous le numéro B 150183.

Ensuite les comparants, agissant en leurs dites qualités, représentant l’intégralité du capital social, ont pris à l’unanimité

la résolution suivante:

<i>Résolution unique

Les associés décident de transférer le siège social de la société avec effet au 1 

er

 octobre 2014, de L-4210 Esch-sur-

Alzette, 58, rue de la Libération à L-3333 Hellange, 53, route de Bettembourg, et de modifier en conséquence le 1 

er

alinéa de l’article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le siège social est établi à Hellange (commune de Frisange).».
Les 2 

ème

 et 3 

ème

 alinéas de l’article 4 des statuts restent inchangés.

<i>Frais

Les frais, dépenses, charges et rémunérations en relation avec les présentes sont tous à charge de la société.
Plus rien d'autre ne se trouvant à l’ordre du jour, les comparants ont déclaré close la présente assemblée.

DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,

états et demeures ils ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: LOSCH, FELIGIONI, MOUTRIER.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 15/09/2014. Relation: EAC/2014/12299. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 01/10/2014.

Référence de publication: 2014151951/39.
(140173633) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2014.

Belux Bois S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8820 Holtz, 9, rue des Bois.

R.C.S. Luxembourg B 104.374.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

L’an deux mil quatorze, le vingt-neuf août,

s’est tenue

par devant le soussigné Maître Camille MINES, notaire de résidence à Capellen,
l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme BELUX BOIS S.A., ayant son siège social à L-8820 Holtz,

9, rue des Bois,

Constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Christine DOERNER, notaire de résidence à Bettembourg en date

du 08 octobre 1998, publié au Mémorial C numéro 926 du 22 décembre 1998,

inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg sous le numéro

B 104.374,

et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d’une assemblée générale extraordinaire sous

seing privé emportant conversion du capital en Euros, en date du 18 septembre 2001, dont un extrait a été publié au
Mémorial C numéro 226 du 09 février 2002.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Yves MAQUET, demeurant à B-6800 Libramont-Chevigny,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Dominique MAQUET, demeurant à B-6800 Libramont-Chevigny.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Olivier MAQUET, demeurant à B-6800 Libramont-Chevigny.
Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d’actions

qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été paraphée «ne varietur» sera enregistrée avec le présent acte.

Il résulte de la liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée et qu’il a donc

pu être fait abstraction des convocations d’usage. Dès lors l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement
délibérer sur l’ordre du jour, dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.

Monsieur le Président expose et prie le notaire d’acter que:
1. Les actions représentant le capital de la société sont détenues par Messieurs Yves, Dominique et Olivier les MA-

QUET, demeurant tous à B-6800 Libramont-Chevigny, chacun pour une action et pour les 1257 autres actions par la

156044

L

U X E M B O U R G

société de droit belge YDOM INVEST sprl avec siège à B-6800 Libramont-Chevigny, 53, route de St Hubert, numéro
d’entreprise 0832 143 105.

2. les actionnaires ont décidé de liquider la Société avec effet immédiat et, pour autant que de besoin, Monsieur Yves

MAQUET, préqualifié, va prendre la qualité de liquidateur;

3. les actionnaires déclarent reprendre par la présente tous les actifs de la Société et prendre en charge tout le passif

de la Société et en particulier le passif occulte et inconnu à ce moment;

5. la Société est partant liquidée et la liquidation est clôturée;
6. les actionnaires donnent pleine et entière décharge aux administrateurs et commissaire aux comptes pour l’exercice

de leur mandat;

7. les livres, documents et pièces relatives à la Société resteront conservés durant cinq ans au domicile du liquidateur

à B-6800 Libramont-Chevigny, 78, rue du Patronage.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, l’assemblée est levée à 15h30.

Dont acte, fait et passé à Capellen, en l’étude du notaire instrumentaire, à la date mentionnée en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau, tous connus du notaire par nom, prénom,

état et demeure, tous ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Y. MAQUET, D. MAQUET, O. MAQUET, C. MINES.
Enregistré à Capellen, le 1 

er

 septembre 2014. Relation: CAP/2014/3332. Reçu soixante-quinze euros 75,-€.

<i>Le Receveur

 (signé): I. Neu.

Pour copie conforme,

Capellen, le 3 septembre 2014.

Référence de publication: 2014151934/51.
(140173034) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2014.

Oxford Street Capital 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Oxford LS 2 S.à r.l.).

Siège social: L-1258 Luxembourg, 22, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 171.460.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 1 

er

 octobre 2014.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2014152272/11.
(140174175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2014.

Antalan Group Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 77.123.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue en date du 07 août 2014

que:

- les démissions de M. Laurent MULLER, M. Frédéric MULLER et M. Tom FABER de leurs fonctions d’administrateur

de la société ont été acceptées;

- La démission de M. Laurent MULLER de sa fonction de Président du Conseil d’Administration a été acceptée.
- Monsieur Eric BERNARD, expert-comptable, né le 15 mai 1965 à Luxembourg, demeurant professionnellement 121,

avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg;

- Monsieur Robert FABER, expert-comptable, né le 15 mai 1964 à Luxembourg, demeurant professionnellement 121,

avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg; et

- Monsieur Oliver BRAZIER, administrateur de sociétés, né le 11 août 1969 à Waiblingen (Allemagne), demeurant

professionnellement à 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg;

ont été nommés aux fonctions d’administrateur de la société.
- Monsieur Eric BERNARD, expert-comptable, né le 15 mai 1965 à Luxembourg, demeurant professionnellement 121,

avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg;

A été nommé à la fonction de Président du Conseil d’Administration de la société.

156045

L

U X E M B O U R G

- La démission de la société MARC MULLER CONSEILS S.A R.L.(anc.Fiduciaire Marc Muller S.à r.l.) de ses fonctions

de Commissaire aux Comptes a été acceptée.

- Mme Anne-Marie PESCH, Expert-Comptable, née le 7 novembre 1977 à Mannheim, demeurant à 44, um Wues

L-6552 Berdorf;

- Les mandats des Administrateurs, du Président du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes pren-

dront fin à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2020.

Lucembourg, le 07 août 2014.

<i>Pour la Société
Un mandataire

Référence de publication: 2014151904/32.
(140173984) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2014.

DF Group SA, Société Anonyme.

Siège social: L-2111 Luxembourg, 1A, rue Guillaume de Machault.

R.C.S. Luxembourg B 85.872.

L'an deux mille quatorze, le vingt-neuf septembre
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S'est réunie

l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "DF GROUP SA", établie et ayant son siège

social à L-3850 Schifflange, 72-80, Avenue de la Libération, constituée suivant acte reçu par Maître Francis KESSELER,
notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 1 

er

 février 2002, publié au Mémorial C numéro 761 du 18 mai 2002,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro numéro B 85872.

La séance est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Monsieur Antonio José DA FONSECA, agent immobilier,

né le 19 mai 1968 à Resende (P), demeurant à L-3521 Dudelange, 37, rue Karl Marx.

Le Président désigne comme secrétaire et scrutateur Monsieur Paulo Carlos DOMINGUES CARMO, agent immobilier,

né le 17 octobre 1974 à Differdange, demeurant professionnellement à L-1941 Luxembourg, 191, route de Longwy.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1.- Transfert du siège social de la société de L-3850 Schifflange, 72-80, avenue de la Libération à L-2111 Luxembourg,

1A, Rue Guillaume De Machault et modification subséquente du premier alinéa de l’article 3 des statuts.

2.- Constat de la démission du commissaire aux comptes en date du 02 septembre 2013 et nomination d'un nouveau

commissaire aux comptes.

3.- Prorogation du mandat des Administrateurs actuellement en fonctions pour une durée de six ans se terminant à

l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2020.

4.- Prorogation du mandat de l’administrateur-délégué actuellement en fonctions pour une durée de six ans se ter-

minant à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2020.

5.- Divers.
II.- Qu'il résulte d'une liste de présence que les CENT (100) actions d'une valeur nominale de TROIS CENT DIX

EUROS (€ 310,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social de TRENTE-ET-UN MILLE EUROS (€ 31.000,-) sont
dûment représentées à la présente assemblée; cette liste de présence, après avoir été signée par les membres du bureau,
restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est en conséquence régulièrement constituée

et peut délibérer valablement sur les points figurant à l’ordre du jour.

L'assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et, après s'être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix, la résolution suivante:

<i>Première résolution

L'assemblée  générale  décide  de  transférer  le  siège  social  de  la  société  de  L-3850  Schifflange,  72-80,  avenue  de  la

Libération à L-2111 Luxembourg, 1A, Rue Guillaume De Machault et de modifier en conséquence le premier alinéa de
l’article 3 des statuts qui aura la teneur suivante:

"Le siège social est établi à Luxembourg.".
Les autres alinéas de l’article 3 restent inchangés.

156046

L

U X E M B O U R G

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale constate la démission en date du 02 septembre 2013 du commissaire aux comptes alors en

fonctions, à savoir la société à responsabilité limitée «Bureau MODUGNO S.à r.l.» (r.c.s.l.: B35.889).

Elle  lui  accorde  bonne  et  valable  quittance  et  décharge  pour  toutes  les  opérations  effectuées  jusqu'au  jour  de  la

démission.

En remplacement de qui l’assemblée générale nomme aux fonctions de Commissaire aux comptes pour une période

de six ans se terminant à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2020:

La société anonyme «GEFCO SA, Gestion financière &amp; Consulting», ayant son siège social à L-3961 Ehlange, 51, Rue

des 3 Cantons, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 44.091.

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale décide la prorogation du mandat des Administrateurs actuellement en fonctions et dont le mandat

arrive à terme à l’issue de l’assemblée générale devant se tenir en l’année 2014.

Le mandat des administrateurs aura une durée de six ans se terminant à l’issue de l’assemblée générale annuelle de

2020.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée générale décide la prorogation du mandat de l’administrateur-délégué actuellement en fonctions et dont

le mandat arrive à terme à l’issue de l’assemblée générale devant se tenir en l’année 2014.

Le mandat de l’administrateur-délégué aura une durée de six ans se terminant à l’issue de l’assemblée générale annuelle

de 2020.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires, quels qu'ils soient, dus en vertu des présentes sont à la charge de la société.

DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par noms,

prénoms, états et demeures, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: DA FONSECA, DOMINGUES CARMO, MOUTRIER.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 30/09/2014. Relation: EAC/2014/13117. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): HALSDORF.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 01/10/2014.

Référence de publication: 2014152011/75.
(140173614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2014.

E.D. Maler- Fassadenarbeiten G.m.b.h., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 114, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 117.326.

Im Jahre zweitausendvierzehn, am Dreißigsten September
Vor der unterzeichnenden Notarin Blanche MOUTRIER, mit Amtssitz in Esch-Alzette.

IST ERSCHIENEN:

Herr Daniel SCHUSTER, Angestellter, geboren am 22 März 1970 zu Thionville (France), wohnhaft in D-66706 Perl,

87, Bergstrasse.

Der vorgenannte Komparent erklärt dass er der alleinige Anteilseigner der Gesellschaft mit beschränkter Haftung E.D.

Maler-Fassadenarbeiten G.m.b.H, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Sitz in L-1511 Luxembourg, 114, Avenue de
la Faïencerie, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 117.326, ist.

Die Gesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Aloyse BIEL, mit Amtssitz in Esch/

Alzette, vom 29. Mai 2006, veröffentlicht im Memorial C Nummer 1619 vom 25. August 2006.

Sodann ersuchte der Komparent, handelnd wie eingangs erwähnt, die amtierende Notarin, folgende Beschlüsse zu

beurkunden:

<i>Erster Beschluss

Die alleinige Anteilseignerin beschliesst den Gegenstand der Gesellschaft zu ändern, sodass Artikel Zwei (2) der Satzung

wie folgt zu lesen ist:

156047

L

U X E M B O U R G

« Art. 2. Die Gesellschaft hat zum Gegenstand:
- Maler und Fassadenarbeiten sowie Fliesenverlegung, mit dem Ankauf und Verkauf jeglicher Artikel welche sich auf

das Objekt der Gesellschaft beziehen, sowie Komplettsanierung von Gebäuden.

- Der Erwerb, der Verkauf, die Verwertung und die Verwaltung von Immobilien aller Art im Grossherzogtum Luxem-

burg und im Ausland Die Gesellschaft kann sich an anderen Gesellschaften mit einem ähnlichen oder komplementaren
Gesellschaftszweck beteiligen und Filialen, Büros oder Zweigstellen in jedem europäischen Land aufrichten.

Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft alle Tätigkeiten kommerzieller, finanzieller oder sonstiger Art ausüben,

soweit sie dem Gesellschaftszweck dienlich oder nützlich sind.».

<i>Zweiter Beschluss

Der alleinige Anteilseigner beschliesst einen zusätzlichen «Technischen Geschäftsführer für Fliesenverlegung» zu er-

nennen für eine unbegrenzte Dauer und zwar:

Herr Mike SCHUSTER, geboren am 27, Juni 1987 zu Saarburg
(D), wohnhaft in D-66693 Mettlach, Freiherr-Vom-Stein-Strasse, 62.

<i>Dritter Beschluss

Der alleinige Anteilseigner beschliesst die Funktion von Markus Helfen zu ändern in «Technischen Geschäftsführer für

Maler und Fassadenarbeiten» umzuändern.

<i>Vierte Beschluss

Die Zeichnungsberechtigung der Geschaftsführer ist jetzt wie folgt:
Die Gesellschaft wird rechtsgültig vertreten durch die gemeinsame Unterschrift des administrativen Geschäftsführers

und eines technischen Geschäftsführers (welcher für die jeweilige Tätigkeit zuständig ist).

<i>Kosten

Die Kosten, welche der Gesellschaft auf Grund vorliegender Urkunde entstehen, gehen zu Lasten der Gesellschaft.
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Komparent, handelnd wie eingangs erwähnt, die Versammlung

für geschlossen.

WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen wurde zu Esch/Alzette, Datum wie Eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden, haben die Komparentinnen zusammen mit der Notarin gegenwärtige Urkunde

unterschrieben.

Signé: SCHUSTER, MOUTRIER.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 01/10/2014. Relation: EAC/2014/13144. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): HALSDORF.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 02/10/2014.

Référence de publication: 2014152014/54.
(140173999) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2014.

Pasha International, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 155.742.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société PASHA INTERNATIONAL S.à.r.l. qui s'est

<i>tenue à Luxembourg, en date du 22 septembre 2014 à 10 heures.

L'assemblée décide:
1. D'accepter le transfert de siège social de la société au 18, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg.
La résolution ayant été adoptée à l'unanimité, la totalité du capital étant représentée.

Luxembourg, le 22 septembre 2014.

<i>Pour la société
Pascale RINGWALD-ANTKOWIAK
<i>Gérante

Référence de publication: 2014153879/17.
(140175981) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2014.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

156048


Document Outline

Activ Fiduciaire S.A.

Agence Fonseca Immobilier Luxembourg

Anoa Capital S.A.

Anoa Capital S.A.

Antalan Group Holding S.A.

AOF3 S.à r.l.

Asco Energie Holdings S.à r.l.

Ascot Luxembourg Holdings 2 S.à r.l.

Belux Bois S.A.

Biminvest S.A.

Biminvest S.A.

Caballo Fello S.à r.l.

CCH S.A.

CNF SA

DF Group SA

Dream Luxco S.C.A.

Dundeal (International) 24 S.à r.l.

ECommerce Holding II S.à r.l.

EcoTree S.A.

E.D. Maler- Fassadenarbeiten G.m.b.h.

F9 A Chateau S.à r.l.

FWP Lux Feeder Gamma Sàrl

Garrison Earlsfort I S.à r.l.

GOLDENBURY (Luxembourg) S.A.

HTTS Management Global Partner S.à r.l.

ICG International Computing Group S.A.

ID Concept S.à r.l.

Imprimerie Gérard Klopp S.à r.l.

INOV

McKesson Information Solutions Holdings S.à r.l.

Mill Luxembourg Holdings 1

Nova Express S.A.

Nova Express S.A., SPF

NSAM Luxembourg S.à r.l.

Oxford Instruments Funding (Luxembourg) S.à r.l.

Oxford LS 1 S.à r.l.

Oxford LS 2 S.à r.l.

Oxford Street Capital 1 S.à r.l.

Oxford Street Capital 2 S.à r.l.

Oxford Street Capital S.à r.l.

Paneuropa Real Estate InvestCo

Pasha International

Pinkerton S.A.

Project Oxford LS S.à r.l.

Reference Automobile S.A.

Sensata Investment Company S.C.A.

SICAV II (Lux)

SKM Krieger S.à r.l.

Vitus Arendahl S.à r.l.