logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 3156

29 octobre 2014

SOMMAIRE

2Win S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

151449

Application Security Consultants S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

151448

Arend & Hansen S.C.I. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

151462

Arend & Partners S.C.I. . . . . . . . . . . . . . . . . .

151462

Ascot Luxembourg Holdings 2 S.à r.l.  . . . .

151487

Atalaya Luxco PIKco  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

151485

bpfBOUW UK Investments S.à r.l. . . . . . . .

151446

Chez les Bons Amis S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

151444

Colonnade Holdco N° 10 S.A.  . . . . . . . . . . .

151444

Colonnade Holdco N° 9 S.A.  . . . . . . . . . . . .

151444

Colux Real Estate S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

151444

Darecko S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

151442

Déco-Peint Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . .

151442

Director S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

151448

eDreams ODIGEO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

151449

Emerging Markets Online Food Delivery

Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

151466

Eurobank Holding (Luxembourg) S.A.  . . .

151447

Euroexp S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

151447

Flying Bird S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

151443

Gasfin Development S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

151443

iBO Solutions S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

151465

Incoden S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

151442

LSREF3 GTC Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

151442

Lux-O-Trend Distribution S.à r.l.  . . . . . . . .

151450

MDT Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

151445

Parker Hannifin Partnership S.C.S.  . . . . . .

151453

PATRIZIA Real Estate 10 S.à r.l.  . . . . . . . .

151448

PATRIZIA Real Estate 20 S.à r.l.  . . . . . . . .

151448

PHM Investment Holdings (EUR) S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

151443

PHM Topco 24 Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . .

151443

Power Group Investments S.à r.l. . . . . . . . .

151443

Ribambelle Groupe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

151443

Rousegaertchen S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

151446

Rovi Global Services S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . .

151446

SaarLux Solutions S. à r. l.  . . . . . . . . . . . . . .

151445

Smart Advisory  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

151445

Sofapi-Lux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

151448

Southerncross Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . .

151445

Tramuntana Management S.à r.l.  . . . . . . . .

151442

Transfert S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

151449

Trends Export S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

151446

Trilux-Stahl, GmbH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

151446

W2007 Parallel Bora S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

151447

W2007 Parallel Lancaster S.à r.l.  . . . . . . . .

151447

Westenwind S.à r.l. & Cie S.C.A.  . . . . . . . .

151444

Westenwind S.à r.l. & Cie S.C.A., SICAR

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

151444

Willis Lux Holdings 2 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

151481

WOF II Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

151449

WOF III Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

151449

Zaza S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

151445

151441

L

U X E M B O U R G

Incoden S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 31, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 98.801.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 septembre 2014.

Référence de publication: 2014146783/10.
(140167032) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2014.

LSREF3 GTC Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 177.929.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 septembre 2014.

Référence de publication: 2014146841/10.
(140167196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2014.

Darecko S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4963 Clémency, 9bis, rue Basse.

R.C.S. Luxembourg B 115.628.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 12 septembre 2014.

Pour statuts coordonnés

Référence de publication: 2014147287/11.
(140167678) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2014.

Déco-Peint Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3835 Schifflange, 13, rue d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 137.004.

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de

résidence à Esch/Alzette, en date du 6 mai 2014 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 6 juin 2014.

Référence de publication: 2014147266/11.
(140168058) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2014.

Tramuntana Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 147.818.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Dudelange.

Carlo GOEDERT
<i>Notaire

Référence de publication: 2014147800/12.
(140167743) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2014.

151442

L

U X E M B O U R G

Power Group Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 6-8, Op der Ahlkärrech.

R.C.S. Luxembourg B 187.952.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 septembre 2014.

Référence de publication: 2014147628/10.
(140168063) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2014.

PHM Topco 24 Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. PHM Investment Holdings (EUR) S.à r.l.).

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 169.744.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 septembre 2014.

Référence de publication: 2014147648/10.
(140167689) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2014.

Ribambelle Groupe, Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 182.259.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 24 septembre 2014

Le siège social est transféré au 23 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Dandois &amp; Meynial

Référence de publication: 2014149095/11.
(140169878) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2014.

Gasfin Development S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8041 Strassen, 65, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 153.190.

Les comptes annuels du 1 

er

 janvier 2013 au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014149460/11.
(140170215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2014.

Flying Bird S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 125.222.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FLYING BIRD S.A.
Signatures
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2014150057/12.
(140171704) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2014.

151443

L

U X E M B O U R G

Colux Real Estate S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4384 Ehlerange, ZARE Ouest.

R.C.S. Luxembourg B 133.582.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014149927/9.
(140171422) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2014.

Chez les Bons Amis S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7740 Colmar-Berg, 29, avenue Gordon Smith.

R.C.S. Luxembourg B 146.157.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014149946/9.
(140171244) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2014.

Colonnade Holdco N° 10 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 124.915.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Colonnade Holdco N° 10 S.A.
Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2014149925/11.
(140171666) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2014.

Colonnade Holdco N° 9 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 123.368.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Colonnade Holdco N° 9 S.A.
Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2014149926/11.
(140171533) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2014.

Westenwind S.à r.l. &amp; Cie S.C.A., Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'In-

vestissement en Capital à Risque,

(anc. Westenwind S.à r.l. &amp; Cie S.C.A., SICAR).

Siège social: L-1528 Luxembourg, 2, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 131.390.

Le bilan, le compte de pertes et profits et la balance au 31 décembre 2012 tel qu'approuvés lors de l’assemblée générale

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour le fonds
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014150484/14.
(140171591) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2014.

151444

L

U X E M B O U R G

SaarLux Solutions S. à r. l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-5450 Stadtbredimus, 5C, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 135.723.

Der Jahresabschluss auf den 31.12.2013 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014150356/9.
(140171248) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2014.

Southerncross Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 200.000,00.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 170.138.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014150369/9.
(140171554) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2014.

MDT Luxembourg, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-1610 Luxembourg, 28, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 105.336.

Les comptes annuels de la société de droit étranger SBA S.A. au 28 février 2014 ont été déposés au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUO

Référence de publication: 2014150395/11.
(140170915) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2014.

Smart Advisory, Société Anonyme Unipersonnelle.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 68, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 106.888.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 septembre 2014.

Smart Advisory S.A.
Signature

Référence de publication: 2014150367/12.
(140171456) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2014.

Zaza S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4761 Pétange, 1B, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 180.377.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

PRODESSE S.à r.l.
19, rue de la Gare
L-3237 BETTEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2014150492/13.
(140170986) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2014.

151445

L

U X E M B O U R G

Trilux-Stahl, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6461 Echternach, 4, Devant le Marché.

R.C.S. Luxembourg B 94.033.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014150456/9.
(140171241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2014.

Trends Export S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 172.232.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014150454/9.
(140171782) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2014.

Rovi Global Services S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 157.159.

Les comptes consolidés au 31 décembre 2013 de la maison-mère, Rovi Corporation, ont été déposés au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014150341/11.
(140171066) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2014.

Rousegaertchen S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 18, rue des Foyers.

R.C.S. Luxembourg B 163.399.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 septembre 2014.

<i>Pour compte de Rousegaertchen S.A.
Fiduplan S.A.

Référence de publication: 2014150353/12.
(140171504) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2014.

bpfBOUW UK Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 160.241.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 septembre 2014.

Jean-Jacques Josset
<i>Gérant A

Référence de publication: 2014147901/13.
(140169273) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2014.

151446

L

U X E M B O U R G

Eurobank Holding (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 118.180.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 17 septembre 2014.

Pour statuts coordonnés

Référence de publication: 2014146669/11.
(140167236) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2014.

Euroexp S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: CHF 20.400,00.

Siège social: L-2242 Luxembourg, 1, rue Isaac Newton.

R.C.S. Luxembourg B 180.360.

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil de Gérance tenue en date du 22 Septembre 2014

Le Conseil décide de:
- transférer le siège social de la société de 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg à 1, rue Isaac Newton, L-2242

Luxembourg

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Référence de publication: 2014148730/13.
(140170023) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2014.

W2007 Parallel Bora S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 20.834,13.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 130.278.

Constituée par devant Me Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20 juin 2007, acte publié au

Mémorial C n° 1971

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

W2007 Parallel Bora S.à r.l.
Marielle Stijger
<i>Gérant

Référence de publication: 2014147860/14.
(140167841) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2014.

W2007 Parallel Lancaster S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 138.939.

Constituée par devant Me Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 30 avril 2008, acte publié au

Mémorial C n° 1532

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

W2007 Parallel Lancaster S.à r.l.
Marielle Stijger
<i>Gérant

Référence de publication: 2014147861/14.
(140168457) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2014.

151447

L

U X E M B O U R G

PATRIZIA Real Estate 10 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 122.981.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014148337/9.
(140168653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2014.

PATRIZIA Real Estate 20 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 122.982.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014148338/9.
(140168807) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2014.

Application Security Consultants S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2734 Luxembourg, 25, rue de Wiltz.

R.C.S. Luxembourg B 171.468.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fiduciaire Internationale SA

Référence de publication: 2014148533/10.
(140170104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2014.

Director S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 20, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 95.613.

<i>Résolution de la gérance prise à Luxembourg en date du 23 septembre 2014:

- La gérance a décidé de transférer avec effet immédiat le siège social de la société du 16 rue de Nassau L-2213

Luxembourg vers le 20 avenue Pasteur L-2310 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014148717/11.
(140169562) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2014.

Sofapi-Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4761 Pétange, 59, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 70.436.

<i>Réunion du conseil d'administration tenue à Pétange en date du 21 août 2014.

Suivant la loi du 28.07.2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur et à la tenue du registre des

actions nominatives et du registre des actions au porteur, publiée au Mémorial A- N° 161 du 14 août 2014,

Le Conseil d'Administration décide de nommer:
la société «SOCIÉTÉ DE GESTION INTERNATIONALE S.à.r.l.», expert-comptable, située à L-4761 Pétange, 59 route

de Luxembourg et inscrite au RCS sous le numéro B77606, dépositaire des titres au porteur de la société.

Pascal WAGNER / Renée WAGNER-KLEIN / Myriam MATHIEU
<i>Administrateur délégué / Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2014149141/15.
(140169839) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2014.

151448

L

U X E M B O U R G

WOF II Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 165.651.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2014149207/10.
(140169849) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2014.

WOF III Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 180.007.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2014149208/10.
(140170165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2014.

Transfert S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8437 Steinfort, 66, rue de Koerich.

R.C.S. Luxembourg B 100.437.

Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014149181/10.
(140169336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2014.

eDreams ODIGEO, Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 159.036.

Les comptes annuels consolidés au 31 mars 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Lu-

xembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg.

Référence de publication: 2014149246/11.
(140170753) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2014.

2Win S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1260 Luxembourg, 5, rue de Bonnevoie.

R.C.S. Luxembourg B 153.752.

Nous vous prions de bien vouloir noter la démission, en date du 26 août 20.14 de son mandat de Commissaire aux

comptes:

- La société Revisora S.A., ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 60, Avenue de la Liberté, R.C.S. Luxembourg

B 145.505.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

2WIN S.A.

Référence de publication: 2014149218/13.
(140169511) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2014.

151449

L

U X E M B O U R G

Lux-O-Trend Distribution S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9638 Pommerloch, 19, rue de Bastogne.

R.C.S. Luxembourg B 190.168.

STATUTS

L'an deux mille quatorze, le neuf septembre,
Par devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

Monsieur Bertrand DE CRAECKER, manager, né le 17 novembre 1978 à Bruxelles (Belgique), demeurant à B-6600

Bastogne, 4, Harzy.

Ledit comparant a requis le notaire instrumentaire de dresser acte d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare

constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1 

er

 .  Il existe une société à responsabilité limitée (la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant

les sociétés commerciales telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, au Grand-Duché de

Luxembourg ou à l'étranger; l'achat, la vente en gros et au détail, l'importation, l'exportation, la représentation de tous
articles de bijouterie, d'horlogerie, d'articles cadeaux, de bijoux fantaisie, en ce compris les accessoires et articles de
dérivés de merchandising. La Société pourra confier tout ou partie des tâches précitées à un tiers professionnel.

La Société a également pour objet l'acquisition, la détention et la gestion de tous immeubles situés au Grand-Duché

de Luxembourg ou à l'étranger, sans but commercial.

Elle peut réaliser toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous

quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement
de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

La Société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s'intéresse direc-

tement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.

Généralement la Société peut réaliser toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière ou immobilière,

prendre toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et faire toutes opérations généralement quelconques, qui se
rattachent à son objet ou qui le favorisent.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société est constituée sous la dénomination de «LUXO-TREND DISTRIBUTION S.à r.l.».

Art. 5. Le siège social est établi dans la commune de Winseler.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en vertu d'une décision de l'assemblée générale des

associés. A l'intérieur de la commune, le siège social pourra être transféré par décision du gérant ou du conseil de gérance.
La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du Grand-Duché de Luxembourg ou dans
tous autres pays par décision du gérant ou du conseil de gérance.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de vingt mille euros (EUR 20.000,-), représenté par cent (100) parts sociales

d'une valeur nominale de deux cents euros (EUR 200,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés représentant

au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales à souscrire seront offertes par préférence aux associés
existants, proportionnellement à la partie du capital qui représente leurs parts sociales en cas de contribution en numé-
raire.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune

d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule
et même personne.

151450

L

U X E M B O U R G

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs

à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social. En cas de décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-
associés que moyennant l'agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts
appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts
sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la Société.

C. Gérance

Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés.
Les gérants sont nommés par l'assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur mandat. Ils sont libre-

ment révocables à tout moment et sans cause.

La Société sera engagée en toutes circonstances par la signature du gérant unique. En cas de pluralité de gérants, la

Société sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux gérants ou par la (les) autre(s) signature
(s) de toute(s) autre(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil de
gérance.

Art. 12. En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance choisira en son sein un président et pourra également

choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être gérant
et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et des assemblées des associés.

Le conseil de gérance se réunira sur la convocation du président ou de deux gérants, au lieu indiqué dans l'avis de

convocation.

Le président présidera toutes les assemblées des associés et les réunions du conseil de gérance; en son absence, les

associés ou le conseil de gérance pourront désigner à la majorité des personnes présentes un autre gérant pour assumer
la présidence pro tempore de telles réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant la

date prévue pour la réunion par courrier électronique, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette
urgence  seront  mentionnés  dans  l'avis  de  convocation.  Il  pourra  être  passé  outre  à  cette  convocation  à  la  suite  de
l'assentiment de chaque gérant par écrit ou par courrier électronique, télécopieur ou tout autre moyen de communication
similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et
un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par courrier

électronique ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, visio-conférence ou

d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre
les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou

représentée à la réunion du conseil de gérance.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion.
Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par courrier électronique, télécopieur ou tout autre moyen de communication
similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 13. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son

absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants.

Art. 14. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 15. Les gérants ne contractent, à raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux enga-

gements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution
de leur mandat.

D. Décisions de l'associé unique - Décisions collectives des associés

Art. 16. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.

Art. 17. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant décision de la majorité des associés représentant les trois quarts

du capital social.

151451

L

U X E M B O U R G

Art. 18. Si la Société n'a qu'un seul associé, cet associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés

par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

E. Année sociale - Bilan - Répartition des bénéfices

Art. 19. L'année sociale commence le premier jour du mois de janvier et se termine le dernier jour du mois de décembre

de la même année.

Art. 20. Chaque année, au dernier jour du mois de décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dresse

(nt) un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre com-
munication au siège social de l'inventaire et du bilan.

Art. 21. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce

que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale. Le
conseil de gérance est autorisé à distribuer des dividendes intérimaires si les fonds nécessaires à une telle distribution
sont disponibles.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 22. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou

non, nommé(s) par l'assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Le ou les liquidateur(s) auront
les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la

Société.

Art. 23. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 telle qu'elle a été modifiée.

<i>Souscription et libération

Toutes les cent (100) parts sociales sont souscrites par Monsieur Bertrand DE CRAECKER, susmentionné, et entiè-

rement  payées  en  numéraire  de  sorte  que  le  montant  de  vingt  mille  euros  (EUR  20.000,-)  de  capital  social  est  dès
maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le dernier jour du mois de

décembre 2014.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution à environ mille euros (EUR 1.000,-).

<i>Résolutions

Et aussitôt l'associé unique a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi à L-9638 Pommerloch, 19, route de Bastogne;
2. L'associé unique décide de nommer Monsieur Bertrand DE CRAECKER, susmentionné, en tant que gérant unique

de la Société pour une durée illimitée.

<i>Avertissement

Le notaire a attiré l'attention du comparant que la Société doit obtenir une autorisation d'établissement de la part des

autorités administratives compétentes en rapport avec son objet social avant de commencer son activité commerciale,
avertissement que le comparant reconnaît avoir reçu.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: B. DE CRAECKER et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 11 septembre 2014. LAC / 2014 / 42267. Reçu soixante quinze euros. 75,-

<i>Le Receveur (signé): THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 16 septembre 2014.

Référence de publication: 2014144253/156.
(140163890) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2014.

151452

L

U X E M B O U R G

Parker Hannifin Partnership S.C.S., Société en Commandite simple.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 158.172.

In the year two thousand and fourteen, on the ninth day of September.
Before Maître Francis KESSELER, notary residing in Esch/Alzette (Grand-Duchy of Luxembourg)

There appeared,

(i) PARKER HANNIFIN PARTNER I GP, a general partnership formed pursuant to the laws of Bermuda, with registered

office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, HM 11, Bermuda, here represented by Maître Nathalie Houllé,
attorney at law with professional residence in Howald (Grand-Duchy of Luxembourg), by virtue of a proxy issued under
private signature;

(ii) PARKER HANNIFIN PARTNER II GP, a general partnership formed pursuant to the laws of Bermuda, with regis-

tered office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, HM 11, Bermuda, here represented by Maître Nathalie
Houllé, attorney at law with professional residence in Howald (Grand-Duchy of Luxembourg), by virtue of a proxy issued
under private signature; and

(iii) PARKER HANNIFIN (BERLUX) Ltd., an exempted company incorporated with limited liability organised under

the laws of Bermuda, having its registered office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda,
registered with the Bermuda Registrar of Companies under number 45527, here represented by Maître Nathalie Houllé,
attorney at law with professional residence in Howald (Grand-Duchy of Luxembourg), by virtue of a proxy issued under
private signature.

The proxies having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and by the

undersigned notary shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The prenamed are all the partners in PARKER HANNIFIN PARTNERSHIP S.C.S., société en commandite simple having

its registered office at 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Com-
panies’ Register under number 158.172, incorporated on December 1 

st

 , 2010 by deed of the undersigned notary,

published in the Mémorial C number 666 on April 7, 2011 (the “Partnership”). The articles of association of the Partnership
have been amended for the last time by deed of the undersigned notary dated January 21, 2014, published in the Mémorial
C number 1981 on July 29, 2014.

Which appearing parties, represented as mentioned above, requested the undersigned notary to draw up the following:
I. That the agenda of the extraordinary general meeting is the following:

<i>Agenda

In the definitions section of the articles of association of the Partnership, amendment of the following defined term so

as to read:

“Subsidiary Sharing Percentages” means the percentages in which each Partner shares in the Subsidiary Profits and

Losses of the respective Subsidiaries as set forth hereafter:

Name

Country

PH

Partner

I

PH

Partner

II

General

Partner

Olaer Fawcett Christie Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

UK

5%

95%

0%

Olaer Italiana SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Italy

5%

95%

0%

Olaer Industries GmbH (Merged April 3, 2014) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Germany

5%

95%

0%

Olaer AB (Merged August 15, 2013) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sweden

5%

95%

0%

Parker Hannifin Holding EMEA S.a.r.l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lux

5%

95%

0%

Parker Hannifin Europe S.a.r.l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lux

95%

5%

0%

Parker Hannifin Lux Finco S.a.r.l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lux

95%

5%

0%

Parker Hannifin Europe Sarl, Luxembourg,
Switzerland Branch, Etoy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CH

95%

5%

0%

Parker Hannifin Lux Finco LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

US

95%

5%

0%

Parker Hannifin Holding EMEA LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

US

95%

5%

0%

Parker Hannifin (Luxembourg) Sarl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lux

95%

5%

0%

Parker International Capital Management
Hungary Limited Liability Company. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hungary

95%

5%

0%

Parker Hannifin France Finance SAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

France

95%

5%

0%

Parker Hannifin 2007 UK LLP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

UK

95%

5%

0%

Parker Origa Holdings Sarl (merged February 26, 2014) . . . . . . . . . . .

CH

95%

5%

0%

151453

L

U X E M B O U R G

Parker Hannifin (Gibraltar) Lux Finco Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gibraltar

95%

5%

0%

Parker Hannifin GesmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Austria

5%

95%

0%

Parker Hannifin Manufacturing Holding Austria GesmbH . . . . . . . . . . .

Austria

5%

95%

0%

Parker Hannifin Manufacturing Austria GmbH
(FKA Parker Origa Pneumatic GmbH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Austria

5%

95%

0%

Parker Hannifin GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Germany

5%

95%

0%

Parker Hannifin Holding GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Germany

5%

95%

0%

Parker Hannifin BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Netherlands

5%

95%

0%

Parker Hannifin BeLux SPRL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Belgium

5%

95%

0%

Parker Hannifin Manufacturing Holding Belgium SPRL . . . . . . . . . . . . .

Belgium

5%

95%

0%

Parker Hannifin Manufacturing Belgium BVBA
(FKA Advanced Products BVBA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Belgium

5%

95%

0%

Parker Canada Holding Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Canada

5%

95%

0%

Parker Canada Investment Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Canada

5%

95%

0%

Parker Ontario Holding Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Canada

5%

95%

0%

Parker Hannifin Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Canada

5%

95%

0%

Parker Hannifin Italy srl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Italy

5%

95%

0%

Parker Hannifin Czech Republic s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Czech

5%

95%

0%

Parker Hannifin Manufacturing Holding Czech Republic s.r.o. . . . . . . . .

Czech

5%

95%

0%

Parker Hannifin Industrial s.r.o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Czech

5%

95%

0%

Parker-Hannifin s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Czech

5%

95%

0%

Parker Hannifin Danmark ApS (FKA Parker Hannifin Sales Aps) . . . . .

Denmark

5%

95%

0%

Parker Hannifin Manufacturing Holding Denmark ApS . . . . . . . . . . . . .

Denmark

5%

95%

0%

Parker Hannifin Manufacturing Denmark ApS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Denmark

5%

95%

0%

Parker Middle East FZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dubai

5%

95%

0%

Parker Italy (PH Espana Holding) LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

US

5%

95%

0%

Parker Hannifin Industries &amp; Assets Holding S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Spain

5%

95%

0%

Parker Hannifin Espana S.L. (FKA Parker Hannifin Espana S.A.) . . . . . .

Spain

5%

95%

0%

Parker Hannifin Manufacturing Finland OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Finland

5%

95%

0%

Parker Hannifin OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Finland

5%

95%

0%

Parker Hannifin France Holding SAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

France

5%

95%

0%

Parker Hannifin France SAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

France

5%

95%

0%

Parker Hannifin Manufacturing France SAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

France

5%

95%

0%

Parker Hannifin SNC (merged January 1, 2014) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

France

5%

95%

0%

Olaer Industries Sarl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

France

5%

95%

0%

Olaer Manufacturing SAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

France

5%

95%

0%

Parker Hannifin Verwaltungs-GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Germany

5%

95%

0%

Parker Hannifin Gebaeudeverwaltung eins GmbH &amp; Co. KG . . . . . . . .

Germany

5%

95%

0%

Parker Hannifin Gebaeudeverwaltung zwei GmbH &amp; Co. KG . . . . . . .

Germany

5%

95%

0%

Parker Hannifin Manufacturing Germany GmbH &amp; Co. KG . . . . . . . . .

Germany

5%

95%

0%

Parker Sales (Ireland) Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ireland

5%

95%

0%

Parker Hannifin Manufacturing Holding Italy srl . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Italy

5%

95%

0%

Parker Hannifin Manufacturing srl (FKA Parker ITR srl) . . . . . . . . . . . .

Italy

5%

95%

0%

Parker Hannifin VAS Netherlands B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Netherlands

5%

95%

0%

Parker Hannifin Manufacturing Netherlands (Filtration) B.V. . . . . . . . .

Netherlands

5%

95%

0%

Parker Hannifin Manufacturing Netherlands (Hose) B.V. . . . . . . . . . . .

Netherlands

5%

95%

0%

Parker Hannifin Manufacturing Netherlands
(Filtration and Separation) B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Netherlands

5%

95%

0%

Parker Hannifin Manufacturing Netherlands (Pneumatic) B.V. . . . . . . .

Netherlands

5%

95%

0%

Parker Hannifin Manufacturing Netherlands (Polyflex) B.V. . . . . . . . . .

Netherlands

5%

95%

0%

GSF Beheer B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Netherlands

5%

95%

0%

GSF Europe B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Netherlands

5%

95%

0%

GSF Kunststoffen B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Netherlands

5%

95%

0%

Parker Hannifin (Norway) Holding A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Norway

5%

95%

0%

151454

L

U X E M B O U R G

Parker Hannifin AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Norway

5%

95%

0%

Parker ScanRope AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Norway

5%

95%

0%

Parker Maritime AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Norway

5%

95%

0%

Parker Hannifin VAS Norway AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Norway

5%

95%

0%

Parker Hannifin Sales Poland Sp z.o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Poland

5%

95%

0%

Parker Hannifin Manufacturing Holding Poland Sp Z.o.o. . . . . . . . . . . .

Poland

5%

95%

0%

Parker Hannifin Manufacturing Poland Sp Z.o.o.
(FKA Parker Hannifin Sp Z.o.o.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Poland

5%

95%

0%

Parker Hannifin Portugal Unipessoal LDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Portugal

5%

95%

0%

Parker Hannifin (Africa) Pty. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S. Africa

5%

95%

0%

Parker Hannifin Manufacturing Holding Spain SL . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Spain

5%

95%

0%

Parker Hannifin Manufacturing Spain SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Spain

5%

95%

0%

Parker Hannifin Aktiebolag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sweden

5%

95%

0%

Parker Hannifin Manufacturing Sweden AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sweden

5%

95%

0%

Parker lklim Kontrol Sistemieri san. Ve Tic. A.S. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Turkey

5%

95%

0%

Parker Hareket ve Kontrol Sistemleri Tic. Ltd. Sirket . . . . . . . . . . . . .

Turkey

5%

95%

0%

Parker Hannifin Industries Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

UK

5%

95%

0%

Commercial Hydraulics Pensions Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

UK

5%

95%

0%

Parker Hannifin Manufacturing (UK) Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

UK

5%

95%

0%

Parker Hannifin (Holdings) Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

UK

5%

95%

0%

Parker Hannifin Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

UK

5%

95%

0%

Alenco (Holdings) Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

UK

5%

95%

0%

Parker Hannifin (GB) Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

UK

5%

95%

0%

Kittiwake Procal Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

UK

5%

95%

0%

Kittiwake Developments Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

UK

5%

95%

0%

Kittiwake Holroyd Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

UK

5%

95%

0%

II. That the extraordinary general meeting of the Partnership has taken the following resolutions:

<i>Sole resolution

The general meeting of the Partnership unanimously resolved to amend, in the definitions section of the articles of

association of the Partnership, the following defined term so as to read:

“Subsidiary Sharing Percentages” means the percentages in which each Partner shares in the Subsidiary Profits and

Losses of the respective Subsidiaries as set forth hereafter:

Name

Country

PH

Partner

I

PH

Partner

II

General

Partner

Olaer Fawcett Christie Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

UK

5%

95%

0%

Olaer Italiana SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Italy

5%

95%

0%

Olaer Industries GmbH (Merged April 3, 2014) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Germany

5%

95%

0%

Olaer AB (Merged August 15, 2013) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sweden

5%

95%

0%

Parker Hannifin Holding EMEA S.a.r.l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lux

5%

95%

0%

Parker Hannifin Europe S.a.r.l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lux

95%

5%

0%

Parker Hannifin Lux Finco S.a.r.l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lux

95%

5%

0%

Parker Hannifin Europe Sarl, Luxembourg,
Switzerland Branch, Etoy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CH

95%

5%

0%

Parker Hannifin Lux Finco LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

US

95%

5%

0%

Parker Hannifin Holding EMEA LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

US

95%

5%

0%

Parker Hannifin (Luxembourg) Sarl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lux

95%

5%

0%

Parker International Capital Management
Hungary Limited Liability Company. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hungary

95%

5%

0%

Parker Hannifin France Finance SAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

France

95%

5%

0%

Parker Hannifin 2007 UK LLP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

UK

95%

5%

0%

Parker Origa Holdings Sarl (merged February 26, 2014) . . . . . . . . . . .

CH

95%

5%

0%

Parker Hannifin (Gibraltar) Lux Finco Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gibraltar

95%

5%

0%

Parker Hannifin GesmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Austria

5%

95%

0%

151455

L

U X E M B O U R G

Parker Hannifin Manufacturing Holding Austria GesmbH . . . . . . . . . . .

Austria

5%

95%

0%

Parker Hannifin Manufacturing Austria GmbH
(FKA Parker Origa Pneumatic GmbH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Austria

5%

95%

0%

Parker Hannifin GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Germany

5%

95%

0%

Parker Hannifin Holding GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Germany

5%

95%

0%

Parker Hannifin BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Netherlands

5%

95%

0%

Parker Hannifin BeLux SPRL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Belgium

5%

95%

0%

Parker Hannifin Manufacturing Holding Belgium SPRL . . . . . . . . . . . . .

Belgium

5%

95%

0%

Parker Hannifin Manufacturing Belgium BVBA
(FKA Advanced Products BVBA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Belgium

5%

95%

0%

Parker Canada Holding Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Canada

5%

95%

0%

Parker Canada Investment Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Canada

5%

95%

0%

Parker Ontario Holding Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Canada

5%

95%

0%

Parker Hannifin Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Canada

5%

95%

0%

Parker Hannifin Italy srl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Italy

5%

95%

0%

Parker Hannifin Czech Republic s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Czech

5%

95%

0%

Parker Hannifin Manufacturing Holding Czech Republic s.r.o. . . . . . . . .

Czech

5%

95%

0%

Parker Hannifin Industrial s.r.o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Czech

5%

95%

0%

Parker-Hannifin s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Czech

5%

95%

0%

Parker Hannifin Danmark ApS (FKA Parker Hannifin Sales Aps) . . . . .

Denmark

5%

95%

0%

Parker Hannifin Manufacturing Holding Denmark ApS . . . . . . . . . . . . .

Denmark

5%

95%

0%

Parker Hannifin Manufacturing Denmark ApS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Denmark

5%

95%

0%

Parker Middle East FZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dubai

5%

95%

0%

Parker Italy (PH Espana Holding) LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

US

5%

95%

0%

Parker Hannifin Industries &amp; Assets Holding S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Spain

5%

95%

0%

Parker Hannifin Espana S.L. (FKA Parker Hannifin Espana S.A.) . . . . . .

Spain

5%

95%

0%

Parker Hannifin Manufacturing Finland OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Finland

5%

95%

0%

Parker Hannifin OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Finland

5%

95%

0%

Parker Hannifin France Holding SAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

France

5%

95%

0%

Parker Hannifin France SAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

France

5%

95%

0%

Parker Hannifin Manufacturing France SAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

France

5%

95%

0%

Parker Hannifin SNC (merged January 1, 2014) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

France

5%

95%

0%

Olaer Industries Sarl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

France

5%

95%

0%

Olaer Manufacturing SAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

France

5%

95%

0%

Parker Hannifin Verwaltungs-GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Germany

5%

95%

0%

Parker Hannifin Gebaeudeverwaltung eins GmbH &amp; Co. KG . . . . . . . .

Germany

5%

95%

0%

Parker Hannifin Gebaeudeverwaltung zwei GmbH &amp; Co. KG . . . . . . .

Germany

5%

95%

0%

Parker Hannifin Manufacturing Germany GmbH &amp; Co. KG . . . . . . . . .

Germany

5%

95%

0%

Parker Sales (Ireland) Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ireland

5%

95%

0%

Parker Hannifin Manufacturing Holding Italy srl . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Italy

5%

95%

0%

Parker Hannifin Manufacturing srl (FKA Parker ITR srl) . . . . . . . . . . . .

Italy

5%

95%

0%

Parker Hannifin VAS Netherlands B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Netherlands

5%

95%

0%

Parker Hannifin Manufacturing Netherlands (Filtration) B.V. . . . . . . . .

Netherlands

5%

95%

0%

Parker Hannifin Manufacturing Netherlands (Hose) B.V. . . . . . . . . . . .

Netherlands

5%

95%

0%

Parker Hannifin Manufacturing Netherlands
(Filtration and Separation) B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Netherlands

5%

95%

0%

Parker Hannifin Manufacturing Netherlands (Pneumatic) B.V. . . . . . . .

Netherlands

5%

95%

0%

Parker Hannifin Manufacturing Netherlands (Polyflex) B.V. . . . . . . . . .

Netherlands

5%

95%

0%

GSF Beheer B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Netherlands

5%

95%

0%

GSF Europe B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Netherlands

5%

95%

0%

GSF Kunststoffen B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Netherlands

5%

95%

0%

Parker Hannifin (Norway) Holding A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Norway

5%

95%

0%

Parker Hannifin AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Norway

5%

95%

0%

Parker ScanRope AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Norway

5%

95%

0%

151456

L

U X E M B O U R G

Parker Maritime AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Norway

5%

95%

0%

Parker Hannifin VAS Norway AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Norway

5%

95%

0%

Parker Hannifin Sales Poland Sp z.o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Poland

5%

95%

0%

Parker Hannifin Manufacturing Holding Poland Sp Z.o.o. . . . . . . . . . . .

Poland

5%

95%

0%

Parker Hannifin Manufacturing Poland Sp Z.o.o.
(FKA Parker Hannifin Sp Z.o.o.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Poland

5%

95%

0%

Parker Hannifin Portugal Unipessoal LDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Portugal

5%

95%

0%

Parker Hannifin (Africa) Pty. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S. Africa

5%

95%

0%

Parker Hannifin Manufacturing Holding Spain SL . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Spain

5%

95%

0%

Parker Hannifin Manufacturing Spain SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Spain

5%

95%

0%

Parker Hannifin Aktiebolag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sweden

5%

95%

0%

Parker Hannifin Manufacturing Sweden AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sweden

5%

95%

0%

Parker lklim Kontrol Sistemieri san. Ve Tic. A.S. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Turkey

5%

95%

0%

Parker Hareket ve Kontrol Sistemleri Tic. Ltd. Sirket . . . . . . . . . . . . .

Turkey

5%

95%

0%

Parker Hannifin Industries Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

UK

5%

95%

0%

Commercial Hydraulics Pensions Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

UK

5%

95%

0%

Parker Hannifin Manufacturing (UK) Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

UK

5%

95%

0%

Parker Hannifin (Holdings) Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

UK

5%

95%

0%

Parker Hannifin Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

UK

5%

95%

0%

Alenco (Holdings) Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

UK

5%

95%

0%

Parker Hannifin (GB) Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

UK

5%

95%

0%

Kittiwake Procal Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

UK

5%

95%

0%

Kittiwake Developments Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

UK

5%

95%

0%

Kittiwake Holroyd Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

UK

5%

95%

0%

There being no other business to be considered on the agenda, the extraordinary general meeting of the Partnership

was closed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing person,

this deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person and in case of
divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof, this deed was drawn up in Howald (Grand-Duchy of Luxembourg), on the date set at the beginning of this

deed.

This  deed  having  been  read  to  the  appearing  person,  known  to  the  notary  by  first  and  surname,  civil  status  and

residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.

Follows the french version

L’an deux mille quatorze, le neuf septembre.
Par-devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg),

Ont comparu

(i) PARKER HANNIFIN PARTNER I GP, une société en nom collectif, constituée selon les lois des Bermudes, avec

siège social au Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, HM 11, Bermudes, ici représentée par Maître Nathalie
Houllé, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Howald (Grand-Duché de Luxembourg), en vertu d'une
procuration délivrée sous seing privé;

(ii) PARKER HANNIFIN PARTNER II GP, une société en nom collectif, constituée selon les lois des Bermudes, avec

siège social au Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, HM 11, Bermudes, ici représentée par Maître Nathalie
Houllé, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Howald (Grand-Duché de Luxembourg), en vertu d'une
procuration délivrée sous seing privé;

(iii) PARKER HANNIFIN BERLUX Ltd., une société exonérée avec une responsabilité limitée constituée selon les lois

de Bermudes, avec siège social au Parker Hannifin (GB) Ltd UK 5% 95% 0% Kittiwake Procal Limited UK 5% 95% 0%
Kittiwake Developments Limited UK 5% 95% 0% Kittiwake Holroyd Limited UK 5% 95% 0% Clarendon House, 2 Church
Street, Hamilton HM 11, Bermudes, immatriculée au Registre des Sociétés des Bermudes sous le numéro 45527, ici
représentée par Maître Nathalie Houllé, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Howald (Grand-Duché de
Luxembourg), en vertu d'une procuration délivrée sous seing privé;

Lesdites procurations après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné resteront annexées

au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.

Les sociétés comparantes prénommées sont tous les associés de PARKER HANNIFIN PARTNERSHIP S.C.S., une

société en commandite simple ayant son siège social au 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, immatriculée au

151457

L

U X E M B O U R G

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 158.172, constituée par un acte daté du 1 

er

décembre 2010 et reçu par le notaire instrumentaire, publié le 7 avril 2011 au Mémorial C numéro 666 (la «Société»).
Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par acte notarié en date du 21 janvier 2014, publié le 29
juillet 2014 au Mémorial C numéro 1981.

Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:

I. Que l’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire soit le suivant:

<i>Ordre du jour

Dans la section des définitions dans les statuts de la Société, modification du terme défini suivant de manière à ce qu'il

prenne la teneur comme suit:

«Pourcentages de Partage de Filiale» signifie les pourcentages selon lesquels chaque Associé partage les Bénéfices et

les Pertes de Filiale de Filiales respectives comme indiqué ci-après:

Nom

Pays

PH

Partner

I

PH

Partner

II

Gérant

Commodité

Olaer Fawcett Christie Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

UK

5%

95%

0%

Olaer Italiana SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Italie

5%

95%

0%

Olaer Industries GmbH (Merged April 3, 2014) . . . . . . . . . . . . . . . . .

Allemagne

5%

95%

0%

Olaer AB (Merged August 15, 2013) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Suède

5%

95%

0%

Parker Hannifin Holding EMEA S.a.r.l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lux

5%

95%

0%

Parker Hannifin Europe S.a.r.l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lux

95%

5%

0%

Parker Hannifin Lux Finco S.a.r.l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lux

95%

5%

0%

Parker Hannifin Europe Sarl, Luxembourg,
Switzerland Branch, Etoy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CH

95%

5%

0%

Parker Hannifin Lux Finco LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

US

95%

5%

0%

Parker Hannifin Holding EMEA LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

US

95%

5%

0%

Parker Hannifin (Luxembourg) Sarl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lux

95%

5%

0%

Parker International Capital Management
Hungary Limited Liability Company. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hongrie

95%

5%

0%

Parker Hannifin France Finance SAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

France

95%

5%

0%

Parker Hannifin 2007 UK LLP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

UK

95%

5%

0%

Parker Origa Holdings Sarl (merged February 26, 2014) . . . . . . . . . . .

CH

95%

5%

0%

Parker Hannifin (Gibraltar) Lux Finco Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gibraltar

95%

5%

0%

Parker Hannifin GesmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Autriche

5%

95%

0%

Parker Hannifin Manufacturing Holding Austria GesmbH . . . . . . . . . .

Autriche

5%

95%

0%

Parker Hannifin Manufacturing Austria GmbH
(FKA Parker Origa Pneumatic GmbH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Autriche

5%

95%

0%

Parker Hannifin GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Allemagne

5%

95%

0%

Parker Hannifin Holding GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Allemagne

5%

95%

0%

Parker Hannifin BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pays-Bas

5%

95%

0%

Parker Hannifin BeLux SPRL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Belgique

5%

95%

0%

Parker Hannifin Manufacturing Holding Belgium SPRL . . . . . . . . . . . .

Belgique

5%

95%

0%

Parker Hannifin Manufacturing Belgium BVBA
(FKA Advanced Products BVBA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Belgique

5%

95%

0%

Parker Canada Holding Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Canada

5%

95%

0%

Parker Canada Investment Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Canada

5%

95%

0%

Parker Ontario Holding Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Canada

5%

95%

0%

Parker Hannifin Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Canada

5%

95%

0%

Parker Hannifin Italy srl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Italie

5%

95%

0%

Parker Hannifin Czech Republic s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . République

Tchèque

5%

95%

0%

Parker Hannifin Manufacturing Holding Czech Republic s.r.o. . . . . . . . République

Tchèque

5%

95%

0%

Parker Hannifin Industrial s.r.o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . République

Tchèque

5%

95%

0%

151458

L

U X E M B O U R G

Parker-Hannifin s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . République

Tchèque

5%

95%

0%

Parker Hannifin Danmark ApS (FKA Parker Hannifin Sales Aps) . . . . . Danemark

5%

95%

0%

Parker Hannifin Manufacturing Holding Denmark ApS . . . . . . . . . . . . Danemark

5%

95%

0%

Parker Hannifin Manufacturing Denmark ApS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danemark

5%

95%

0%

Parker Middle East FZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dubai

5%

95%

0%

Parker Italy (PH Espana Holding) LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

US

5%

95%

0%

Parker Hannifin Industries &amp; Assets Holding S.L. . . . . . . . . . . . . . . . .

Espagne

5%

95%

0%

Parker Hannifin Espana S.L. (FKA Parker Hannifin Espana S.A.) . . . . .

Espagne

5%

95%

0%

Parker Hannifin Manufacturing Finland OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Finlande

5%

95%

0%

Parker Hannifin OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Finlande

5%

95%

0%

Parker Hannifin France Holding SAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

France

5%

95%

0%

Parker Hannifin France SAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

France

5%

95%

0%

Parker Hannifin Manufacturing France SAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

France

5%

95%

0%

Parker Hannifin SNC (merged January 1, 2014) . . . . . . . . . . . . . . . . .

France

5%

95%

0%

Olaer Industries Sarl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

France

5%

95%

0%

Olaer Manufacturing SAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

France

5%

95%

0%

Parker Hannifin Verwaltungs-GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Allemagne

5%

95%

0%

Parker Hannifin Gebaeudeverwaltung eins GmbH &amp; Co. KG . . . . . . .

Allemagne

5%

95%

0%

Parker Hannifin Gebaeudeverwaltung zwei GmbH &amp; Co. KG . . . . . .

Allemagne

5%

95%

0%

Parker Hannifin Manufacturing Germany GmbH &amp; Co. KG . . . . . . . .

Allemagne

5%

95%

0%

Parker Sales (Ireland) Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Irlande

5%

95%

0%

Parker Hannifin Manufacturing Holding Italy srl . . . . . . . . . . . . . . . . .

Italie

5%

95%

0%

Parker Hannifin Manufacturing srl (FKA Parker ITR srl) . . . . . . . . . . .

Italie

5%

95%

0%

Parker Hannifin VAS Netherlands B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pays-Bas

5%

95%

0%

Parker Hannifin Manufacturing Netherlands (Filtration) B.V. . . . . . . . .

Pays-Bas

5%

95%

0%

Parker Hannifin Manufacturing Netherlands (Hose) B.V. . . . . . . . . . .

Pays-Bas

5%

95%

0%

Parker Hannifin Manufacturing Netherlands
(Filtration and Separation) B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pays-Bas

5%

95%

0%

Parker Hannifin Manufacturing Netherlands (Pneumatic) B.V. . . . . . . .

Pays-Bas

5%

95%

0%

Parker Hannifin Manufacturing Netherlands (Polyflex) B.V. . . . . . . . .

Pays-Bas

5%

95%

0%

GSF Beheer B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pays-Bas

5%

95%

0%

GSF Europe B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pays-Bas

5%

95%

0%

GSF Kunststoffen B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pays-Bas

5%

95%

0%

Parker Hannifin (Norway) Holding A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Norvège

5%

95%

0%

Parker Hannifin AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Norvège

5%

95%

0%

Parker ScanRope AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Norvège

5%

95%

0%

Parker Maritime AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Norvège

5%

95%

0%

Parker Hannifin VAS Norway AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Norvège

5%

95%

0%

Parker Hannifin Sales Poland Sp z.o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pologne

5%

95%

0%

Parker Hannifin Manufacturing Holding Poland Sp Z.o.o. . . . . . . . . . .

Pologne

5%

95%

0%

Parker Hannifin Manufacturing Poland Sp Z.o.o.
(FKA Parker Hannifin Sp Z.o.o.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pologne

5%

95%

0%

Parker Hannifin Portugal Unipessoal LDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Portugal

5%

95%

0%

Parker Hannifin (Africa) Pty. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Afrique du

Sud

5%

95%

0%

Parker Hannifin Manufacturing Holding Spain SL . . . . . . . . . . . . . . . . .

Espagne

5%

95%

0%

Parker Hannifin Manufacturing Spain SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Espagne

5%

95%

0%

Parker Hannifin Aktiebolag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Suède

5%

95%

0%

Parker Hannifin Manufacturing Sweden AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Suède

5%

95%

0%

Parker lklim Kontrol Sistemieri san. Ve Tic. A.S. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Turquie

5%

95%

0%

Parker Hareket ve Kontrol Sistemleri Tic. Ltd. Sirket . . . . . . . . . . . . .

Turquie

5%

95%

0%

Parker Hannifin Industries Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

UK

5%

95%

0%

Commercial Hydraulics Pensions Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

UK

5%

95%

0%

Parker Hannifin Manufacturing (UK) Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

UK

5%

95%

0%

151459

L

U X E M B O U R G

Parker Hannifin (Holdings) Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

UK

5%

95%

0%

Parker Hannifin Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

UK

5%

95%

0%

Alenco (Holdings) Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

UK

5%

95%

0%

Parker Hannifin (GB) Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

UK

5%

95%

0%

Kittiwake Procal Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

UK

5%

95%

0%

Kittiwake Developments Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

UK

5%

95%

0%

Kittiwake Holroyd Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

UK

5%

95%

0%

II. Que l’assemblée générale extraordinaire de la Société a pris la décision unique suivante:

<i>Décision unique

L’assemblée générale extraordinaire de la Société a décidé à l’unanimité de modifier, dans la section des définitions

dans les statuts de la Société, le terme défini suivant de manière à ce qu'il prenne la teneur comme suit:

«Pourcentages de Partage de Filiale» signifie les pourcentages selon lesquels chaque Associé partage les Bénéfices et

les Pertes de Filiale de Filiales respectives comme indiqué ci-après:

Nom

Pays

PH

Partner

I

PH

Partner

II

Gérant

Commodité

Olaer Fawcett Christie Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

UK

5%

95%

0%

Olaer Italiana SpA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Italie

5%

95%

0%

Olaer Industries GmbH (Merged April 3, 2014) . . . . . . . . . . . . . . . . .

Allemagne

5%

95%

0%

Olaer AB (Merged August 15, 2013) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Suède

5%

95%

0%

Parker Hannifin Holding EMEA S.a.r.l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lux

5%

95%

0%

Parker Hannifin Europe S.a.r.l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lux

95%

5%

0%

Parker Hannifin Lux Finco S.a.r.l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lux

95%

5%

0%

Parker Hannifin Europe Sarl, Luxembourg,
Switzerland Branch, Etoy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CH

95%

5%

0%

Parker Hannifin Lux Finco LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

US

95%

5%

0%

Parker Hannifin Holding EMEA LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

US

95%

5%

0%

Parker Hannifin (Luxembourg) Sarl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lux

95%

5%

0%

Parker International Capital Management
Hungary Limited Liability Company. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hongrie

95%

5%

0%

Parker Hannifin France Finance SAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

France

95%

5%

0%

Parker Hannifin 2007 UK LLP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

UK

95%

5%

0%

Parker Origa Holdings Sarl (merged February 26, 2014) . . . . . . . . . . .

CH

95%

5%

0%

Parker Hannifin (Gibraltar) Lux Finco Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gibraltar

95%

5%

0%

Parker Hannifin GesmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Autriche

5%

95%

0%

Parker Hannifin Manufacturing Holding Austria GesmbH . . . . . . . . . .

Autriche

5%

95%

0%

Parker Hannifin Manufacturing Austria GmbH
(FKA Parker Origa Pneumatic GmbH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Autriche

5%

95%

0%

Parker Hannifin GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Allemagne

5%

95%

0%

Parker Hannifin Holding GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Allemagne

5%

95%

0%

Parker Hannifin BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pays-Bas

5%

95%

0%

Parker Hannifin BeLux SPRL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Belgique

5%

95%

0%

Parker Hannifin Manufacturing Holding Belgium SPRL . . . . . . . . . . . .

Belgique

5%

95%

0%

Parker Hannifin Manufacturing Belgium BVBA
(FKA Advanced Products BVBA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Belgique

5%

95%

0%

Parker Canada Holding Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Canada

5%

95%

0%

Parker Canada Investment Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Canada

5%

95%

0%

Parker Ontario Holding Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Canada

5%

95%

0%

Parker Hannifin Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Canada

5%

95%

0%

Parker Hannifin Italy srl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Italie

5%

95%

0%

Parker Hannifin Czech Republic s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . République

Tchèque

5%

95%

0%

Parker Hannifin Manufacturing Holding Czech Republic s.r.o. . . . . . . . République

Tchèque

5%

95%

0%

151460

L

U X E M B O U R G

Parker Hannifin Industrial s.r.o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . République

Tchèque

5%

95%

0%

Parker-Hannifin s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . République

Tchèque

5%

95%

0%

Parker Hannifin Danmark ApS (FKA Parker Hannifin Sales Aps) . . . . . Danemark

5%

95%

0%

Parker Hannifin Manufacturing Holding Denmark ApS . . . . . . . . . . . . Danemark

5%

95%

0%

Parker Hannifin Manufacturing Denmark ApS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danemark

5%

95%

0%

Parker Middle East FZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dubai

5%

95%

0%

Parker Italy (PH Espana Holding) LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

US

5%

95%

0%

Parker Hannifin Industries &amp; Assets Holding S.L. . . . . . . . . . . . . . . . .

Espagne

5%

95%

0%

Parker Hannifin Espana S.L. (FKA Parker Hannifin Espana S.A.) . . . . .

Espagne

5%

95%

0%

Parker Hannifin Manufacturing Finland OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Finlande

5%

95%

0%

Parker Hannifin OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Finlande

5%

95%

0%

Parker Hannifin France Holding SAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

France

5%

95%

0%

Parker Hannifin France SAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

France

5%

95%

0%

Parker Hannifin Manufacturing France SAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

France

5%

95%

0%

Parker Hannifin SNC (merged January 1, 2014) . . . . . . . . . . . . . . . . .

France

5%

95%

0%

Olaer Industries Sarl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

France

5%

95%

0%

Olaer Manufacturing SAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

France

5%

95%

0%

Parker Hannifin Verwaltungs-GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Allemagne

5%

95%

0%

Parker Hannifin Gebaeudeverwaltung eins GmbH &amp; Co. KG . . . . . . .

Allemagne

5%

95%

0%

Parker Hannifin Gebaeudeverwaltung zwei GmbH &amp; Co. KG . . . . . .

Allemagne

5%

95%

0%

Parker Hannifin Manufacturing Germany GmbH &amp; Co. KG . . . . . . . .

Allemagne

5%

95%

0%

Parker Sales (Ireland) Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Irlande

5%

95%

0%

Parker Hannifin Manufacturing Holding Italy srl . . . . . . . . . . . . . . . . .

Italie

5%

95%

0%

Parker Hannifin Manufacturing srl (FKA Parker ITR srl) . . . . . . . . . . .

Italie

5%

95%

0%

Parker Hannifin VAS Netherlands B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pays-Bas

5%

95%

0%

Parker Hannifin Manufacturing Netherlands (Filtration) B.V. . . . . . . . .

Pays-Bas

5%

95%

0%

Parker Hannifin Manufacturing Netherlands (Hose) B.V. . . . . . . . . . .

Pays-Bas

5%

95%

0%

Parker Hannifin Manufacturing Netherlands
(Filtration and Separation) B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pays-Bas

5%

95%

0%

Parker Hannifin Manufacturing Netherlands (Pneumatic) B.V. . . . . . . .

Pays-Bas

5%

95%

0%

Parker Hannifin Manufacturing Netherlands (Polyflex) B.V. . . . . . . . .

Pays-Bas

5%

95%

0%

GSF Beheer B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pays-Bas

5%

95%

0%

GSF Europe B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pays-Bas

5%

95%

0%

GSF Kunststoffen B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pays-Bas

5%

95%

0%

Parker Hannifin (Norway) Holding A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Norvège

5%

95%

0%

Parker Hannifin AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Norvège

5%

95%

0%

Parker ScanRope AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Norvège

5%

95%

0%

Parker Maritime AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Norvège

5%

95%

0%

Parker Hannifin VAS Norway AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Norvège

5%

95%

0%

Parker Hannifin Sales Poland Sp z.o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pologne

5%

95%

0%

Parker Hannifin Manufacturing Holding Poland Sp Z.o.o. . . . . . . . . . .

Pologne

5%

95%

0%

Parker Hannifin Manufacturing Poland Sp Z.o.o.
(FKA Parker Hannifin Sp Z.o.o.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pologne

5%

95%

0%

Parker Hannifin Portugal Unipessoal LDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Portugal

5%

95%

0%

Parker Hannifin (Africa) Pty. Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Afrique du

Sud

5%

95%

0%

Parker Hannifin Manufacturing Holding Spain SL . . . . . . . . . . . . . . . . .

Espagne

5%

95%

0%

Parker Hannifin Manufacturing Spain SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Espagne

5%

95%

0%

Parker Hannifin Aktiebolag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Suède

5%

95%

0%

Parker Hannifin Manufacturing Sweden AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Suède

5%

95%

0%

Parker lklim Kontrol Sistemieri san. Ve Tic. A.S. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Turquie

5%

95%

0%

Parker Hareket ve Kontrol Sistemleri Tic. Ltd. Sirket . . . . . . . . . . . . .

Turquie

5%

95%

0%

Parker Hannifin Industries Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

UK

5%

95%

0%

151461

L

U X E M B O U R G

Commercial Hydraulics Pensions Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

UK

5%

95%

0%

Parker Hannifin Manufacturing (UK) Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

UK

5%

95%

0%

Parker Hannifin (Holdings) Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

UK

5%

95%

0%

Parker Hannifin Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

UK

5%

95%

0%

Alenco (Holdings) Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

UK

5%

95%

0%

Parker Hannifin (GB) Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

UK

5%

95%

0%

Kittiwake Procal Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

UK

5%

95%

0%

Kittiwake Developments Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

UK

5%

95%

0%

Kittiwake Holroyd Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

UK

5%

95%

0%

N’ayant plus rien à l’ordre du jour à considérer, l’assemblée générale extraordinaire a été clôturée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande du comparant, le présent acte est

rédigé en français, suivi d’une version anglaise; à la demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, passé à Howald (Grand-Duché de Luxembourg), date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom, état

et demeure, ledit comparant a signé avec le notaire le présent.

Signé: Houllé, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette, Actes Civils le 11 septembre 2014. Relation: EAC/2014/12171. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur ff.

 (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2014145020/514.
(140164439) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2014.

Arend &amp; Hansen S.C.I., Société Civile,

(anc. Arend &amp; Partners S.C.I.).

Siège social: L-7535 Mersch, 14, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg E 3.202.

L'an deux mille quatorze, le quatrième jour du mois de septembre.
Par devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché du Luxembourg,

Ont comparu:

- La société anonyme ACTA PRIV II S.A., avec siège social à L-7535 Mersch, 14, rue de la Gare, enregistrée au Registre

de Commerce et de Société sous le numéro B.178.157,

ici représentée par deux administrateurs Madame Sylvie HANSEN (épouse WINKIN), née le 08 février 1973 à Wiltz,

demeurant professionnellement à L-7535 Mersch, 14, rue de la Gare et Monsieur Nico AREND, 23 janvier 1950 à Cler-
vaux, demeurant professionnellement à L-7535 Mersch, 14, rue de la Gare, lequel est ici représenté par Madame Sylvie
HANSEN (épouse WINKIN), prénommée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 29 août 2014.

- La société à responsabilité limitée MAUCED s.à r.l., avec siège social à L-9647 Doncols, 28, Duerfstroos, enregistrée

au Registre de Commerce et de Sociétés sous le numéro B.118.342,

ici représentée par sa gérante unique Madame Sylvie HANSEN (épouse WINKIN), prénommée.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante repré-

sentée, le comparant présent et le notaire instrumentant, annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la
formalité de l'enregistrement.

Lesquelles comparantes, représentées comme mentionné ci-avant, ont exposé au notaire instrumentant et l'ont requis

d'acter ce qui suit:

I.- Les comparantes, prénommées, représentées comme mentionné ci-avant, sont les seules et uniques associés de la

société civile immobilière "AREND &amp; PARTNERS S.C.I.», avec siège social à L-7535 Mersch, 14, rue de la Gare, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro E 3.202, constituée suivant acte reçu par
Maître Léonie Grethen, alors notaire de résidence à Rambrouch, en date du 25 août 2006, publiée au Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations numéro 2040 du 31 octobre 2006, et dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis
sa constitution (ci-après «la Société»).

II.- Le capital social de la Société est de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-) représenté par cent (100) parts sociales

sans valeur nominale, toutes les parts sociales étant entièrement souscrites et libérées par les associés.

III. Que l'actif immobilier de la société se compose uniquement des biens et droits immobiliers suivants:
Dans l'immeuble en copropriété sis à L-7535 Mersch, 12, rue de la Gare, inscrit au cadastre comme suit:

151462

L

U X E M B O U R G

COMMUNE DE MERSCH, section D de Beringen
numéro 215/2183, lieu-dit «rue de la Gare», place (occupée), bâtiment à appartements, d'une contenance de 9 ares

82 centiares:

1.- lot 001:
inscrit au cadastre sous le numéro 001.A.B.81,
soit la propriété privative et exclusive d'une cave, d'une surface utile d'après cadastre de 23.92 m2,
avec 13.258/1.000es dans les parties communes, y compris le sol;
2.- lot 002:
inscrit au cadastre sous le numéro 002.A.A.00,
soit la propriété privative et exclusive d'un bureau, d'une surface utile d'après cadastre de 189.01 m2,
avec 419.033/1.000es dans les parties communes, y compris le sol;
3.- lot 004:
inscrit au cadastre sous le numéro 004.B.U.00,
soit la propriété privative et exclusive d'un emplacement extérieur, d'une surface utile d'après cadastre de 11.37 m2,
avec 7.562/1.000es dans les parties communes, y compris le sol;
4.- lot 006:
inscrit au cadastre sous le numéro 006. B.U.00,
soit la propriété privative et exclusive d'un emplacement extérieur, d'une surface utile d'après cadastre de 12.14 m2,
avec 8.074/1.000es dans les parties communes, y compris le sol;
5.- lot 007:
inscrit au cadastre sous le numéro 007. B.U.00,
soit la propriété privative et exclusive d'un emplacement extérieur, d'une surface utile d'après cadastre de 11.93 m2,
avec 7.935/1.000es dans les parties communes, y compris le sol;
6.- lot 008:
inscrit au cadastre sous le numéro 008. B.U.00,
soit la propriété privative et exclusive d'un emplacement extérieur, d'une surface utile d'après cadastre de 12.04 m2,
avec 8.008/1.000es dans les parties communes, y compris le sol;
7.- lot 009:
inscrit au cadastre sous le numéro 009. B.U.00, soit la propriété privative et exclusive d'un emplacement extérieur,

d'une surface utile d'après cadastre de 11.99 m2, avec 7.974/1.000es dans les parties communes, y compris le sol;

8.- lot 010:
inscrit au cadastre sous le numéro 010. B.U.00, soit la propriété privative et exclusive d'un emplacement extérieur,

d'une surface utile d'après cadastre de 12.01 m2, avec 7.988/1.000es dans les parties communes, y compris le sol;

9.- lot 011:
inscrit au cadastre sous le numéro 011. B.U.00,
soit la propriété privative et exclusive d'un emplacement extérieur, d'une surface utile d'après cadastre de 12.04 m2,
avec 8.008/1.000es dans les parties communes, y compris le sol;
10.- lot 012:
inscrit au cadastre sous le numéro 012. B.U.00,
soit la propriété privative et exclusive d'un emplacement extérieur, d'une surface utile d'après cadastre de 12.11 m2,
avec 8.054/1.000es dans les parties communes, y compris le sol;
11.- lot 013:
inscrit au cadastre sous le numéro 013. B.U.00,
soit la propriété privative et exclusive d'un emplacement extérieur, d'une surface utile d'après cadastre de 12.07 m2,
avec 8.028/1.000es dans les parties communes, y compris le sol;
12.- lot 014:
inscrit au cadastre sous le numéro 014. B.U.00,
soit la propriété privative et exclusive d'un emplacement extérieur, d'une surface utile d'après cadastre de 12.09 m2,
avec 8.041/1.000es dans les parties communes, y compris le sol;
13.- lot 015:
inscrit au cadastre sous le numéro 015. B.U.00,
soit la propriété privative et exclusive d'un emplacement extérieur, d'une surface utile d'après cadastre de 12.12 m2,
avec 8.061/1.000es dans les parties communes, y compris le sol;

151463

L

U X E M B O U R G

14.- lot 025:
inscrit au cadastre sous le numéro 025. A.A.01,
soit la propriété privative et exclusive d'un bureau, d'une surface utile d'après cadastre de 88.67 m2,
avec 196.581/1.000es dans les parties communes, y compris le sol;
15.- lot 026:
inscrit au cadastre sous le numéro 026. A.A.02,
soit la propriété privative et exclusive d'un bureau, d'une surface utile d'après cadastre de 89.24 m2,
avec 177.957/1.000es dans les parties communes, y compris le sol;
16.- lot 027:
inscrit au cadastre sous le numéro 027. A.A.02,
soit la propriété privative et exclusive d'un bureau, d'une surface utile d'après cadastre de 2.79 m2,
avec 6.185/1.000es dans les parties communes, y compris le sol;
TOTAL DES MILLIEMES DE COPROPRIETE ATTACHES AUX LOTS: neuf cents virgule sept cent quarante sept

millièmes (900.747/1.000es).

<i>Origine de propriété

1. La société civile immobilière «AREND &amp; PARTNERS S.C.I.» a acquis les lots prédésignés de Nico AREND en vertu

d'un acte de vente immobilière reçu par Maître Léonie Grethen, alors notaire de résidence à Rambrouch, en date du 11
octobre 2006, transcrit au premier bureau des hypothèques à Luxembourg, le 14 novembre 2006, volume 2023, numéro
94.

2.- Les contenances et superficies indiquées ci-avant d'après les données du cadastre pour les immeubles ne sont

portées qu'à titre de renseignement et sans préjudice des contenances et superficies effectives des immeubles, sans aucune
exception ni réserve des différents immeubles qui composent la propriété lors même qu'ils auraient été omis dans la
désignation détaillée qui précède, avec les immeubles par destination qui en dépendent et les améliorations et augmen-
tations qui pourraient y être faites.

<i>Cessions de parts sociales

V.- Il résulte de deux cessions de parts sociales intervenues sous seing privé, dès avant la signature des présentes et

hors la présence du notaire instrumentant, en date du 29 août 2014,lesquelles ont été déjà enregistrés, que la société à
responsabilité limitée «CAPIGEST SARL», avec siège social à L-9170 Mertzig, 14, Zechel et enregistrée au Registre de
Commerce et de Sociétés sous le numéro B 118.160, a cédé et transporté, avec effet au 29 août 2014, toutes ses vingt
(20) parts sociales, qu'elle détenait dans la société civile immobilière «AREND &amp; PARTNERS S.C.I.», à raison de 10 (dix)
parts en faveur de la société anonyme ACTA PRIV II S.A., prénommée, et à raison de 10 (dix) parts en faveur de la société
à responsabilité limitée MAUCED s.à r.l., prénommée, cet acceptant, au prix de cession convenu entre parties qui est
payable conformément aux délais et modalités de paiement arrêtés entre parties suivant convention sous seing privé.

Les cessionnaires se trouvent subrogées dans tous les droits et obligations attachés aux parts sociales leur cédées à

partir de ce jour.

VI. Pour des raisons d'opposabilité à la société et aux tiers, Monsieur Nico AREND, prénommé, et Madame Sylvie

HANSEN, prénommée, en leur qualité de gérants de la Société «AREND &amp; PARTNERS S.C.I.», déclarent accepter la
prédite cession de parts sociales au nom et pour compte de la Société, conformément à l'article 1690 du Code civil.

VII. En raison des prédites cessions de parts sociales, les parts sociales de la Société «AREND &amp; PARTNERS S.C.I.»

appartiennent entièrement aux associés comme suit:

- société ACTA PRIV II S.A., pré-qualifiée,
Soixante quinze parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75

- société MAUCED s.à r.l., pré-qualifiée,
Vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

Total: Cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

<i>Assemblée générale extraordinaire

VIII. Suite aux cessions de parts sociales reprises ci-avant, les associés prénommés, représentant l'intégralité du capital

social, se sont réuni en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se considèrent comme dûment convoqués et ont
reconnu être pleinement informé des résolutions à prendre sur base de l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour

1. Constatation de la présence de deux associés dans la Société;
2. Constatation de la démission de Madame Mia VAN DE BERG en tant que gérante de la Société et décharge à lui

accorder pour l'exécution de son mandat;

151464

L

U X E M B O U R G

3. Changement de la dénomination sociale de «AREND &amp; PARTNERS S.C.I.» en «AREND &amp; HANSEN S.C.I.» et

modification subséquente de l'article 1 des statuts de la Société;

4. Divers.
Après en avoir délibéré, les comparantes, représentées comme mentionné ci-avant, ont pris, à l'unanimité, les réso-

lutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés constatent que la Société n'a plus que deux associés en les personnes de:
- la société ACTA PRIV II S.A., pré-qualifiée (anciennement ACTA PRIV S.A., la société ACTA PRIV II S.A. est devenue

associée en raison d'une scission partielle datée du 25 mars 2013 dans laquelle les 65 parts sociales de la société AREND
&amp; PARTNERS S.C.I., initialement détenues par ACTA PRIV S.A. ont été transférées à la Société ACTA PRIV II S.A., et en
raison de la prédite cession de part de 10 parts sociales sous seing privée datée du 29 août 2014) et

- la société MAUCED s.à r.l., pré-qualifiée (laquelle est devenue associée lors de la constitution de la société civile

immobilière AREND &amp; PARTNERS S.C.I. et en raison de la prédite cession de part de 10 parts sociales sous seing privée
datée du 29 août 2014)

<i>Deuxième résolution

Les associés constatent et acceptent la démission de Madame Mia VAN DE BERG, née le 04 février 1961, demeurant

à L-9170 Mertzig, 14, Zechel, en tant que gérante de la Société civile immobilière «AREND &amp; PARTNERS S.C.I.» et
décident de lui accorder décharge pour l'exécution de son mandat jusqu'à la date du 29 août 2014.

Les associés confirment les mandats de gérants de la Société de Monsieur Nico AREND et Madame Sylvie HANSEN,

nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée.

<i>Troisième résolution

Les associés décident de changer la dénomination sociale de «AREND &amp; PARTNERS S.C.I.» en «AREND &amp; HANSEN

S.C.I.».

Afin de mettre les statuts en concordance avec la modification qui précède, les associés décident de modifier l'article

1 des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

Art. 1 

er

 .  «Il est formé par les présentes une société civile immobilière qui prendra la dénomination de AREND &amp;

HANSEN S.C.I.».»

<i>Frais

Les frais et honoraires en relation avec le présent acte sont tous à charge de la Société et des comparants prénommés,

lesquels s'engagent solidairement, indivisiblement et personnellement avec la Société pour ce qui est du paiement desdits
frais et honoraires envers le notaire soussigné.

DONT ACTE, fait et passé à Mersch, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires des comparantes, connus du notaire instrumentaire

par noms, prénoms, états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: S. HANSEN, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 05 septembre 2014. Relation: DIE/2014/11271. Reçu sept mille huit cents euros (7800.-) euros.

<i>Le Receveur (signé): pd: RECKEN.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Diekirch, le 16 septembre 2014.

Référence de publication: 2014143911/180.
(140164245) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2014.

iBO Solutions S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 11, route des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 145.742.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés, dans leur version abrégée, au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg conformément à l'art. 79(1) de la loi du 19/12/2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Mandataire

Référence de publication: 2014149249/11.
(140170892) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2014.

151465

L

U X E M B O U R G

Emerging Markets Online Food Delivery Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 64.572,00.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 7, avenue J.P. Pescatore.

R.C.S. Luxembourg B 175.738.

In the year two thousand and fourteen, on the fourteenth day of August,
before us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

1. Rocket Internet AG, a stock corporation (Aktiengesellschaft) existing under the laws of Germany, registered with

the commercial register at the local court of Charlottenburg, Germany, under no. HRB 159634 B, having its registered
address at Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Germany,

being the holder of twenty-one thousand sixty (21,060) common shares, one hundred eighty (180) series A1a shares,

eighty-three (83) series A2a shares, and five thousand eight hundred thirty-one (5,831) series B5 shares, and becoming
the holder of one thousand eight hundred ten (1,810) series C shares of the Company,

here represented by Mrs. Antje Reibold, Rechtsanwältin, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy,

given in Berlin, Germany, on 31 July 2014 and given in Munich, Germany, on 12 August 2014.

2. Kinnevik Online AB (formerly Kinnevik Online Ventures AB), a limited liability company (aktiebolag) existing under

the laws of Sweden registered with the company registrar in Sweden (Bolagsverket), under no. 556815-4958, having its
registered address at Skeppsbron 18, 10313 Stockholm, Sweden,

being the holder of one thousand eight hundred seven (1,807) series A1b, one hundred nine (109) series A1c shares

and eight hundred twenty-eight (828) series A2b shares of the Company,

here represented by Mrs. Antje Reibold, Rechtsanwältin, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy,

given in Stockholm, Sweden, on 30 July 2014,

3.  Bambino  53.  V  V  UG  (haftungsbeschränkt),  a  limited  liability  company  (Unternehmergesellschaft  (haftungsbes-

chränkt)) incorporated and existing under the laws of Germany registered with the commercial register at the local court
of Charlottenburg, Germany, under no. HRB 126893 B, having its registered address at Johannisstraße 20, 10117 Berlin,
Germany,

being the holder of one hundred and five (105) common shares of the Company,
here represented by Mrs. Antje Reibold, Rechtsanwältin, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy,

given in Berlin, Germany, on 29 July 2014,

4. AI European Holdings S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée) existing under the laws of

the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Com-
merce et des Sociétés) under no. B 168.122, having its registered address at 15-17, avenue Gaston Diderich, L-1420
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

being the holder of eight hundred and twenty-eight (828) series A2b shares of the Company,
here represented by Mrs. Antje Reibold, Rechtsanwältin, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy,

given in London, United Kingdom, on 30 July 2014, and in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 30 July 2014,

5. Aismare Lux Holdings S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée) existing under the laws of

the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Com-
merce et des Sociétés) under number B 176544, having its registered address at 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365
Munsbach, the Grand Duchy of Luxembourg, and with a share capital of forty-three thousand euros (EUR 43,000),

being the holder of three thousand seven hundred and fifty (3,750) series B1 shares and seven hundred thirty-four

(734) series B5 shares of the Company,

here represented by Mrs. Antje Reibold, Rechtsanwältin professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy,

given in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 6 August 2014,

6. Phenomen Ventures LP, an exempted Limited Partnership incorporated and existing under the laws of the Cayman

Islands, registration number OG - 66003, having its registered office at 89 Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman
KY1-9007, Cayman Islands, represented by its General Partner, Phenomen Ventures Management, an exempted company
incorporated and existing under the Law of the Cayman Islands, registered with Registry of Companies, Cayman Islands,
under number OG-271195, having its registered address at 89 Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman KY1-9007,
Cayman Islands,

being the holder of four thousand six hundred eighty-seven (4,687) series B2 shares and one thousand three hundred

thirty-eight (1,338) series B4 shares of the Company,

here represented by Mrs. Antje Reibold, Rechtsanwältin, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy,

given in Moscow, on 4 August 2014,

151466

L

U X E M B O U R G

7. Mercura Capital GmbH (formerly Schuler-Beteiligungen GmbH), a limited liability company (Gesellschaft mit bes-

chränkter Haftung) existing under the laws of Germany with its statutory seat in Starnberg, Germany, registered with
the  commercial  register  at  the  local  court  of  Munich  under  no.  HRB  200948,  having  its  business  address  at
Schließstättstraße 22, 82319 Starnberg, Germany,

being the holder of one thousand eight hundred seventy-five (1,875) series B3 shares and one thousand two hundred

fifty (1,250) series B4 shares of the Company,

here represented by Mrs. Antje Reibold, Rechtsanwältin, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy,

given in Starnberg, Germany, on 29 July 2014,

8. Luxor Capital Partners, LP, an exempted Limited Partnership incorporated and existing under the laws of Cayman

Islands, having its registered office at 1114 Avenue of the Americas, 29 

th

 Floor, New York, NY 10036, USA, and registered

with the Secretary of State of the State of Delaware under number 3470427, represented by its General Partner LCG
Holdings, LLC, a limited liability company incorporated and existing under the laws of Delaware, registered with with the
Secretary of State of the State of Delaware, having its registered office and principal place of business at 1114 Avenue of
Americas, 29 

th

 Floor, New York, NY 10036,

being the holder of two thousand five hundred ninety-eight (2,598) series B4 shares and one thousand five hundred

eighty-six (1,586) series B5 shares, and becoming the holder of two thousand four hundred seventy-one (2,471) series
C shares of the Company,

here represented by Mrs. Antje Reibold, Rechtsanwältin, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy,

given in New York, United States of America, on 30 July 2014,

9. Luxor Capital Partners Offshore Master Fund, LP, an exempted Limited Partnership incorporated and existing under

the laws of Cayman Islands, having its registered office at 1114 Avenue of the Americas, 29 

th

 Floor, New York, NY

10036, USA, represented by its General Partner LCG Holdings, LLC, a limited liability company incorporated and existing
under the laws of Delaware, registered with with the Secretary of State of the State of Delaware, having its registered
office and principal place of business at 1114 Avenue of Americas, 29 

th

 Floor, New York, NY 10036,

being the holder of four thousand seventy-eight (4,078) series B4 shares and five hundred ninety-eight (598) series B5

shares, and becoming the holder of two thousand seven hundred eight-four (2,784) series C shares of the Company,

here represented by Mrs. Antje Reibold, Rechtsanwältin, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy,

given in New York, United States of America, on 30 July 2014, and

10. Luxor Wavefront, LP, an exempted Limited Partnership incorporated and existing under the laws of Cayman Islands,

having its registered office at 1114 Avenue of the Americas, 29 

th

 Floor, New York, NY 10036, USA, represented by its

General Partner LCG Holdings, LLC, a limited liability company incorporated and existing under the laws of Delaware,
registered with with the Secretary of State of the State of Delaware, having its registered office and principal place of
business at 1114 Avenue of Americas, 29 

th

 Floor, New York, NY 10036,

being the holder of eight hundred twenty-four (824) series B4 shares and one hundred forty-one (141) series B5 shares,

and becoming the holder of five hundred thirty-eight (538) series C shares of the Company,

here represented by Mrs. Antje Reibold, Rechtsanwältin, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy,

given in New York, United States of America, on 30 July 2014.

11. FEC Lux S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the

laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de
Commerce et des Sociétés) under no. B 173487, having its registered address at 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653
Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg (hereafter referred to as “FEC”), participating and voting only for purposes
of agenda point 4 et seqq.,

becoming the holder of two thousand six hundred seventy-nine (2,679) series C shares of the Company,
here represented by Mrs. Antje Reibold, Rechtsanwältin, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy,

given in Luxembourg, on 6 August 2014.

The said proxies, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary will remain annexed

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The parties 1. through 10. (the “Existing Shareholders”) are all the shareholders of Emerging Markets Online Food

Delivery Holding S.à r.l. (the “Company”), a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of
the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 7, avenue J.P. Pescatore, L-2324 Luxembourg, registered
with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 175.738 and incorporated pursuant to a deed of
Maître Jean-Joseph Wagner on 28 February 2013, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations
number 956 dated 22 April 2013. The articles of association were amended for the last time pursuant to a deed of the
notary Maître Henri Hellinckx on 10 June 2014, not yet published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The Existing Shareholders representing the entire share capital and having waived any notice requirement, the general

meeting of shareholders is regularly constituted and may validly deliberate on the following agenda whereby FEC parti-
cipates and votes for purposes of agenda point 4 et seqq. only:

151467

L

U X E M B O U R G

<i>Agenda

1. Decision to create one (1) additional class of shares, referred to as the series C shares (hereinafter “Series C

Shares”), and to hence have twelve (12) classes of shares in total.

2. Acceptance of FEC Lux S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing

under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
(Registre de Commerce et des Sociétés) under no. B 173487, having its registered address at 2-8, avenue Charles de
Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, as new shareholder of the Company.

3. Increase of the Company’s share capital by an amount of ten thousand two hundred and eighty-two euros (EUR

10,282) so as to raise it from its current amount of fifty-four thousand two hundred ninety euros (EUR 54,290) up to
sixty-four  thousand  five  hundred  seventy-two  euros  (EUR  64,572)  by  issuing  ten  thousand  two  hundred  eighty-two
(10,282) Series C Shares, having a nominal value of one euro (EUR 1) each.

4. Subsequent amendment of article 5 of the articles of association of the Company so that it shall henceforth read as

follows:

“ 5.1. The Company’s share capital is set at sixty-four thousand five hundred seventy-two euros (EUR 64,572), repre-

sented by (i) twenty one thousand one hundred and sixty-five (21,165) common shares (hereinafter “Common Shares”),
(ii) one hundred and eighty (180) series A1a shares (hereinafter “Series A1a Shares”), (iii) one thousand eight hundred
and seven (1,807) series A1b shares (hereinafter “Series A1b shares”), (iv) one hundred and nine (109) series A1c shares
(hereinafter “Series A1c Shares”), (v) eighty-three (83) series A2a shares (hereinafter “Series A2a Shares”), (vi) one
thousand six hundred and fifty-six (1,656) series A2b shares (hereinafter “Series A2b Shares”), (vii) three thousand seven
hundred and fifty (3,750) series B1 shares (hereinafter “Series B1 Shares”), (viii) four thousand six hundred and eighty-
seven (4,687) series B2 shares (hereinafter “Series B2 Shares”, (ix) one thousand eight hundred and seventy-five (1,875)
series B3 shares (hereinafter “Series B3 Shares”), (x) ten thousand eighty-eight (10,088) series B4 shares (hereinafter
“Series B4 Shares”), (xi) eight thousand eight hundred ninety (8,890) series B5 shares (hereinafter “Series B5 Shares” and
together with the Series B1 Shares, the Series B2 Shares, the Series B3 Shares and the Series B4 Shares, the “Series B
Shares”) and (xii) ten thousand two hundred and eighty-two (10,282) series C shares (hereinafter “Series C Shares”),
with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each.

The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by these

articles of association or by the Law.

5.2. The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.3. Each of (i) Rocket Internet AG, (ii) Kinnevik Online AB, (iii) Al European Holdings S.à r.l., (iv) Aismare Lux Holdings

S.à r.l. (v) Phenomen Ventures LP, (vi) Mercura Capital GmbH and (vii) Luxor Capital Partners, LP, Luxor Capital Partners
Offshore Master Fund, LP and Luxor Wavefront, LP (jointly “LuxorCap”) (Luxor Capital Partners, LP, Luxor Capital
Partners Offshore Master Fund, LP and Luxor Wavefront, LP shall exercise their rights under these Articles jointly as if
they were one shareholder; Luxor Capital Partners, LP shall be entitled to make and receive all declarations on behalf of
itself, Luxor Capital Partners Offshore Master Fund, LP and Luxor Wavefront, LP regarding rights and obligations resulting
from shares held by any of them) and (viii) FEC Lux S.à r.l. shall be entitled to subscribe for such amount of further shares
to be issued in the course of a capital increase implementing an investment offer of a third party (being neither a share-
holder nor a company affiliated to a shareholder within the meaning of sections 15 et seqq. German Stock Corporation
Act (AktG) (a “Third Party Investor”)) and which has been approved by the Advisory Board (a “Third Party Investment”)
- irrespective whether made by the Third Party Investor or one or more matching shareholders -required to maintain
up to its percentage ownership in the Company prior to such capital increase under the same terms and conditions on
which the Third Party Investment is based on. Each of (i) Rocket Internet AG, (ii) Kinnevik Online AB, (iii) Al European
Holdings S.à r.l., (iv) Aismare Lux Holdings S.à r.l., (v) Phenomen Ventures LP, (vi) Mercura Capital GmbH, (vii) LuxorCap
and (viii) FEC Lux S.à r.l. shall inform the Company by binding declaration within three (3) weeks after they have been
notified by the Company regarding the Third Party Investment if Rocket Internet AG and/or Kinnevik Online AB and/or
Al European Holdings S.à r.l. and/or Aismare Lux Holdings S.à r.l. and/or Phenomen Ventures LP and/or Mercura Capital
GmbH and/or LuxorCap and/or FEC Lux S.à r.l. intends to exercise its right pursuant to the foregoing sentence of this
Article 5.3. This Article 5.3 shall apply mutatis mutandis in case any of the Investors subscribes for further shares in the
Company.”

5. Subsequent amendment of article 7.4 of the articles of association of the Company so that it shall henceforth read

as follows:

“ 7.4. Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer

given by shareholders holding at least three quarters of the share capital (a “Super Majority”) and subject to the provisions
of any shareholders agreement between the shareholders if any, in particular, any rights of first refusal, rights of pre-

151468

L

U X E M B O U R G

emption or tag-along rights or drag-along rights contained in any shareholders agreement between the shareholders. To
the extent that such approval has been granted, an additional consent to the transfer of shares is not required:

a) in any case of a sale, transfer, assignment or any other disposal of shares by any of (i) Rocket Internet AG, (ii)

Kinnevik Online AB, (iii) Al European Holdings S.à r.l., (iv) Aismare Lux Holdings S.à r.l., (v) Phenomen Ventures LP, (vi)
Mercura Capital GmbH and (vii) Luxor Capital, Luxor Offshore and Luxor Wavefront (Luxor Capital acting for itself as
well as for Luxor Offshore and for Luxor Wavefront and exercising their rights under these articles resulting from shares
held by any of them jointly as if they were one shareholder) (Rocket Internet AG, Kinnevik Online AB, Al European
Holdings S.à r.l., Aismare Lux Holdings S.à r.l., Phenomen Ventures LP, Mercura Capital GmbH, Luxor Capital, Luxor
Offshore, Luxor Wavefront and FEC Lux S.à r.l. hereinafter jointly referred to as “Investors”; each individually an “In-
vestor”) to a company affiliated within the meaning of sections 15 et seqq. German Stock Corporation Act (AktG) to the
respective Investor;

b) in case of a sale, transfer, assignment or any other disposal of shares of one Investor to a company or entity (x)

which is directly or indirectly Controlling, Controlled by or under common Control with (i) this Investor or (ii) by one
or more direct or indirect controlling shareholders of the respective Investor (each a “Controlled Company”), whereas
“Control” or “Controlled” or “Controlling” shall mean the direct or indirect domination of the company or entity by
way of (a) managing the company as managing shareholder, (b) holding the majority of shares, (c) holding the majority of
voting rights by means of a contractual voting pool, or (d) the unilateral ability to cause, directly or indirectly, the direction
of the management and policies of a person, whether through the ownership of voting securities or otherwise, or (y) in
which the respective Investor or one or more shareholders of such Investor has a direct or indirect majority shareholding;

c) in case of a sale, transfer, assignment or any other disposal of shares to a third party acquiring shares under the

simplified employee participation, or by a shareholder to the Company and/or any Investors pursuant to a call option
under a vesting scheme.”

6. Subsequent amendment of article 8 of the articles of association of the Company so that it shall henceforth read as

follows:

“ 8.1. In case (i) of any sale of at least fifty percent (50%) of all shares in the Company, or a swap or a take-over of the

Company in an economically comparable way in a single or more related transactions or in close time proximity to one
another, or (ii) of the liquidation of the Company or (iii) of any sale or transfer of shares in the Company either to third
parties or other shareholders that would result in either more than fifty percent (50%) of the share capital or more than
fifty percent (50%) of the voting rights being owned by the acquiring party/parties (change of control) as a result of one
or more related acquisitions, (each of the events described in (i), (ii) and (iii) is hereinafter referred to as a “Liquidity
Event”), the proceeds (“Exit Proceeds”) - subject to articles 8.2, 8.3 and 8.4 below - will be distributed in accordance
with article 8.5 to the shareholders pro rata corresponding to their participation in the Liquidity Event.

8.2. On a first level (“First Level”) the holders of Series C Shares shall receive an amount of EUR 2,762.94 per Series

C Share which equals the amount of their respective total investment made in the Company (consisting of the nominal
amount of the Series C Shares acquired by that holder and any share premium and/or other capital contribution (account
115) paid by that holder to the Company).

8.3. On a second level (“Second Level”) the holders of Series B Shares shall receive an amount of EUR 1,600 per Series

B Share which equals the amount of their respective total investment made in the Company (consisting of the nominal
amount of the Series B Shares acquired by that holder and any share premium and/or other capital contribution (account
115) paid by that holder to the Company)

8.4. On a third level (“Third Level”) the holders of Series A1a Shares, Series A1b Shares, Series A1c Shares, Series

A2a Shares, Series A2b Shares shall receive per share of the respective share class (and among the shareholders of each
share class pro rata to their shareholding in the respective share class) the amount stipulated as follows:

Share Class

Amount

per Sha-

re

in Euro

Series A1a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,380.84
Series A1b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,383.14
Series A1c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.00

Series A2a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,556.82
Series A2b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,554.76

8.5. After the payments on the First Level and the Second Level and the Third Level have been made, the remaining

Exit Proceeds shall be allocated on a fourth level (“Fourth Level”) to all shareholders pro rata corresponding to their
participation in the Liquidity Event. Any amounts received by any shareholder on the First Level and/or the Second Level
and/or the Third Level shall reduce the amount to be allocated to such shareholder on the Fourth Level and shall be
allocated subsequently pursuant to this Fourth Level provided that no shareholder shall be obliged to repay any amount
received on the First Level and/or the Second Level and/or the Third Level. The allocation at the Fourth Level shall be

151469

L

U X E M B O U R G

made until all Exit Proceeds have been distributed to the shareholders. Irrespective of whether or not the sale of shares
is made in one Liquidity Event or after the Liquidity Event in one transaction or more transactions no shareholder shall
receive for the sale of all of its shares an amount exceeding the higher of (i) its share in the total Exit Proceeds or proceeds
pro rata to the shares sold or (ii) the amount allocated to such shareholder on the First Level and/or the Second Level
and/or the Third Level. In case an exceeding amount is received, the receiving shareholder shall repay such excess amount
accordingly to the other shareholders. All rights related to the liquidity preference stipulated herein are satisfied once
the amount set forth in sentence 1 of this Section 8.5 has been received regarding the respective shares.

8.6. The preferred allocation on the First Level and the Second Level and the Third Level applies to each of the

respective Series C Shares, Series B Shares, Series A1a Shares, Series A1b Shares, Series A1c Shares, Series A2a Shares,
Series A2b Shares as long as on the respective Series C Shares, Series B Shares, Series A1a Shares, Series A1b Shares,
Series A1c Shares, Series A2a Shares, Series A2b Shares, the amount stipulated in article 8.2 and/or in the table pursuant
to article 8.4 has not yet been distributed once.”

7. Subsequent amendment of article 17.1 of the articles of association of the Company so that it shall henceforth read

as follows:

“ 17.1. Resolutions regarding the following subjects must be taken by a Super Majority and any such measure also

requires the consent of the Advisory Board:

a) disposition of all the Company’s assets, of a significant part of the Company’s assets or all or significant part of assets

of any direct or indirect subsidiary of the Company including the resolution with respect to the liquidation of the Company;

b) disposition of shares in direct or indirect subsidiaries of the Company, except for share transfers under the simplified

employee participation as agreed by the shareholders in any shareholders agreement;

c) amendment of these articles of association (including this Article 17) including the resolution with respect to the

merger, separation and transformation of the Company;

d) appropriation of the annual results; payments of profits to capital reserves or the carrying forward of such profits

to new accounts; increase or reduction of (distributable) reserves (including but not limited to share premium and assi-
milated premium) as well as capital increase from company funds; payment of interim dividends; payment of proceeds as
per Article 8 (“liquidation and sale preferences”);

e) conclusion of intra-group agreements (Unternehmensverträge within the meaning of sections 291 et seqq. of the

German Stock Corporation Act (AktG));

f) conclusion of company participations of any kind including silent partnerships and all agreements by which the other

contractual party is granted a participation in the Company’s profit or any payment that is dependent on the amount of
the Company’s profit; this does not include agreements under the simplified employee participation as agreed by the
shareholders in any shareholders agreement;

g) approval of the annual plan, in particular the budget plan for each following year and the annual accounts;
h) removal and appointment of managers.”
8. Subsequent amendment of article 17.2 of the articles of association of the Company so that it shall henceforth read

as follows:

“ 17.2. Resolutions regarding the following subjects must be taken by a Super Majority and any such measure also

requires the consent of all of the Investors.

a) exclusion of subscription rights in case of capital increases;
b) acquisition of the Company’s own shares, including redemption of shares with the exception of acquisitions in

accordance with article 9.2 and transfers in accordance with article 11.1 of these articles of association.”

9. Subsequent amendment of article 22.8 of the articles of association of the Company so that it shall henceforth read

as follows:

“ 22.8. The managers shall require the consent of the Advisory Board for the legal transactions and measures of the

Company and its direct or indirect subsidiaries specified below. No consent is required if such legal transactions and
measures have been precisely defined and have in advance been approved by an adopted budget with the consent of the
shareholders’ meeting:

a) incorporation, acquisition or disposal of enterprises, entities or partial-businesses;
b) amendment of articles of association, shareholder agreements and similar contracts as well as exercise (or waiver)

of shareholders’ rights in companies in which an interest is held directly or indirectly (provided that with respect to
companies in which an interest is held only indirectly, the managers shall procure that such consent requirement is
complied with by the respective direct shareholder);

c) acquisition, sale and encumbrance of real estate and similar rights or rights in real estate;
d) material change to the nature of the business of the Company and the termination of any material business operation;
e) assumption of sureties, guarantees or similar liabilities in excess of an amount of two hundred thousand euro (EUR

200,000) in aggregate;

151470

L

U X E M B O U R G

f) granting of loans in excess of two hundred thousand euro (EUR 200,000) in aggregate, excluding, however, such

loans between the Company and direct and indirect subsidiaries of the Company;

g) conclusion and termination of credit and loan agreements and other financial agreements in excess of two hundred

thousand euro (EUR 200,000) in aggregate and amendments to the credit framework, excluding, however, such agree-
ments between the Company and direct and indirect subsidiaries of the Company;

h) futures transactions concerning currencies, securities and exchange-traded goods and rights as well as other trans-

actions with derivative financial instruments;

i) granting, introduction and amendment of pension commitments of any kind;
j) conclusion amendment or termination of company collective agreements, works agreements (of substantial impor-

tance) and of general guidelines regarding the company pension scheme;

k) institution and termination of legal disputes, in particular, arbitration proceedings involving a judicial amount in

controversy of more than ten thousand euro (EUR 10,000) in the individual case;

l) disposition of rights of use of any kind with respect to intellectual property rights including copyrights or any other

property rights as well as the passing on of know-how for the independent exploitation by the enterprise and/or a third
party, excluding, however, such dispositions between the Company and direct and indirect subsidiaries of the Company;

m) transactions between (i) on the one hand the company and its affiliated companies and (ii) on the other hand

shareholders of the Company and/or their affiliates;

n) amendment and termination of intra-group agreements (Unternehmensverträge within the meaning of articles 291

et seqq. of the German Stock Corporation Act (AktG));

o) exercise of voting rights and other rights in a company in which the Company is a shareholder to the extent that

this exercise would require the consent of the shareholders’ meeting under these articles of association if the Company
was concerned, i.e. according to this article 22.8 lit. a) to o), article 17.1 or 17.2.

Resolutions regarding the introduction of an employee participation scheme require the consent of the Advisory

Board.”

10. Subsequent amendment of article 25.1 of the articles of association of the Company so that it shall henceforth read

as follows:

“ 25.1. The Company shall have an advisory board (the “Advisory Board”). It shall consist of eight (8) voting members.

The shareholders’ meeting may by way of unanimous shareholders’ resolution increase or decrease the number of mem-
bers of the Advisory Board. Each of the shareholders may nominate a non-voting member of the Advisory Board.”

11. Subsequent amendment of article 25.3 of the articles of association of the Company so that it shall henceforth read

as follows:

25.3. The voting members of the Advisory Board shall be nominated by the shareholders by written notification

towards the Company as follows:

a) one (1) voting member of the Advisory Board shall be nominated by the shareholder Rocket Internet AG in its sole

discretion (such member the “Rocket-Member”);

b) one (1) voting member of the Advisory Board shall be nominated by the shareholder Kinnevik Online AB in its sole

discretion;

c) one (1) voting member of the Advisory Board shall be nominated by the shareholder AI European Holdings S.à r.l.

in its sole discretion;

d) one (1) voting member of the Advisory Board shall be nominated by the shareholder Aismare Lux Holdings S.à r.l.

in its sole discretion;

e) one (1) voting member of the Advisory Board shall be nominated by the shareholder Phenomen Ventures LP in its

sole discretion;

f) one (1) voting member of the Advisory Board shall be nominated by the shareholder Mercura Capital GmbH in its

sole discretion;

g) one (1) voting member of the Advisory Board shall be nominated by the shareholders LuxorCap in their sole

discretion; and

h) one (1) voting member of the Advisory Board shall be nominated by the shareholder FEC Lux S.à r.l. in its sole

discretion.”

12. Subsequent amendment of article 25.4 of the articles of association of the Company so that it shall henceforth read

as follows:

“ 25.4. The Advisory Board shall have a chairman and a deputy chairman. The Rocket-Member shall be the chairman

of the Advisory Board and shall not have a casting vote. Each voting member shall have one (1) vote, except the voting
member nominated by Rocket, which shall have five (5) votes and except the voting member nominated by LuxorCap,
which shall have three (3) votes and except for the voting member nominated by Kinnevik, which shall have two (2) votes.
The rules of procedure of the Advisory Board shall provide for further provisions in particular on the self-organisation
of the Advisory Board.”

151471

L

U X E M B O U R G

13. Miscellaneous.
Having duly considered each item of the agenda, the general meeting of shareholders unanimously takes the following

resolutions:

<i>First resolution

The general meeting of shareholders decides to create one (1) additional class of shares referred to as series C shares

(hereinafter “Series C Shares”) and to hence have twelve (12) classes of Shares in total.

<i>Second resolution

The general meeting of shareholders accepts FEC as new shareholder of the Company.

<i>Third resolution

The general meeting of shareholders resolves to increase the share capital of the Company by an amount of ten

thousand two hundred eighty-two euros (EUR 10,282) so as to raise it from its current amount of fifty-four thousand
two hundred ninety euros (EUR 54,290) up to sixty-four thousand five hundred seventy-two euros (EUR 64,572) by
issuing ten thousand two hundred eighty-two (10,282) Series C Shares, having a nominal value of one euro (EUR 1) each
and to subsequently amend article 5 of the articles of associations of the Company which shall now read as set out in the
agenda of the present deed.

<i>Subscription

- One thousand eight hundred and ten (1,810) Series C Shares have been duly subscribed by Rocket Internet AG,

aforementioned, for the price of one thousand eight hundred and ten euro (EUR 1,810);

- two thousand four hundred seventy-one (2,471) Series C Shares have been duly subscribed by Luxor Capital Partners,

LP, aforementioned, for the price of two thousand four hundred seventy-one euros (EUR 2,471);

- two thousand seven hundred eighty-four (2,784) Series C Shares have been duly subscribed by Luxor Capital Partners

Offshore Master Fund, LP, aforementioned, for the price of two thousand seven hundred eighty-four euro (EUR 2,784);

-five hundred thirty-eight (538) Series C Shares have been duly subscribed by Luxor Waterfront, LP, aforementioned,

for the price of five hundred thirty-eight euros (EUR 538); and

- two thousand six hundred seventy-nine (2,679) Series C Shares have been duly subscribed by FEC, aforementioned,

for the price of two thousand six hundred seventy-nine euro (EUR 2,679).

<i>Payment

The one thousand eight hundred and ten (1,810) Series C Shares subscribed by Rocket Internet AG, aforementioned,

the two thousand four hundred seventy-one (2,471) Series C Shares subscribed by Luxor Capital Partners, LP, afore-
mentioned, the two thousand seven hundred eighty-four (2,784)) Series C Shares subscribed by Luxor Capital Partners
Offshore Master Fund, LP, aforementioned, the five hundred thirty-eight (538) Series C Shares subscribed by Luxor
Waterfront, LP, aforementioned, and the two thousand six hundred seventy-nine (2,679) Series C Shares subscribed by
FEC, aforementioned, have been entirely paid up through a contribution in cash in an amount of ten thousand two hundred
and eighty-two euro (EUR 10,282).

The proof of the existence and of the value of the above contribution has been produced to the undersigned notary.
The contribution in the amount of ten thousand two hundred and eighty-two euro (EUR 10,282) is entirely allocated

to the share capital.

<i>Fourth resolution

The general meeting of shareholders acknowledges that FEC has now become holder of two thousand six hundred

seventy-nine (2,679) Series C Shares.

As a consequence FEC, entitled to vote and here represented by Mrs. Antje Reibold, Rechtsanwältin, professionally

residing in Luxembourg, by virtue of the aforementioned proxy, joins the general meeting of shareholders for purpose
of the following resolutions.

The general meeting of shareholders resolves the amendment of article 5 of the articles of association of the Company

so that it shall now henceforth read as set out in the agenda of the present deed.

<i>Fifth resolution

The general meeting of shareholders resolves the amendment of article 7.4a) of the articles of association of the

Company so that it shall now henceforth read as set out in the agenda of the present deed.

<i>Sixth resolution

The general meeting of shareholders resolves the amendment of article 8 of the articles of association of the Company

so that it shall now henceforth read as set out in the agenda of the present deed.

151472

L

U X E M B O U R G

<i>Seventh resolution

The  general  meeting  of  shareholders  resolves  the  amendment  of  article  17.1  of  the  articles  of  association  of  the

Company so that it shall now henceforth read as set out in the agenda of the present deed.

<i>Eight resolution

The  general  meeting  of  shareholders  resolves  the  amendment  of  article  17.2  of  the  articles  of  association  of  the

Company so that it shall now henceforth read as set out in the agenda of the present deed.

<i>Ninth resolution

The  general  meeting  of  shareholders  resolves  the  amendment  of  article  22.8  of  the  articles  of  association  of  the

Company so that it shall now henceforth read as set out in the agenda of the present deed.

<i>Tenth resolution

The  general  meeting  of  shareholders  resolves  the  amendment  of  article  25.1  of  the  articles  of  association  of  the

Company so that it shall now henceforth read as set out in the agenda of the present deed.

<i>Eleventh resolution

The  general  meeting  of  shareholders  resolves  the  amendment  of  article  25.3  of  the  articles  of  association  of  the

Company so that it shall now henceforth read as set out in the agenda of the present deed.

<i>Twelfth resolution

The  general  meeting  of  shareholders  resolves  the  amendment  of  article  25.4  of  the  articles  of  association  of  the

Company so that it shall now henceforth read as set out in the agenda of the present deed.

There being no further business, the meeting is closed.

<i>Costs and expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are

estimated at approximately EUR 2,500.-

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,

the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing party and
in case of divergence between the English and the German text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxyholders of the appearing parties, known to the notary by name, first

name and residence, the said proxyholders signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausendvierzehn, am vierzehnten August,
vor dem unterzeichnenden Notar Maître Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,

SIND ERSCHIENEN:

1. Rocket Internet AG, eine Aktiengesellschaft mit beschränkter Haftung nach deutschem Recht, eingetragen im Han-

delsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland, unter der Nummer HRB 159634 B, mit Sitz in Johannisstraße
20, 10117 Berlin, Deutschland,

Inhaberin von einundzwanzigtausendsechzig (21.060) Stammanteilen, einhundertachtzig (180) Anteilen der Serie A1a,

dreiundachtzig (83) Anteilen der Serie A2a und fünftausendachthunderteinunddreißig (5.831) Anteilen der Serie B5, und
wird zum Inhaber von tausendachthundertzehn (1.810) Anteilen der Serie c der Gesellschaft,

hier vertreten durch Frau Antje Reibold, Rechtsanwältin, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom

31. Juli 2014, ausgestellt in Berlin, Deutschland, und in München, Deutschland, am 12. August 2014.

2. Kinnevik Online AB (vormals Kinnevik Online Ventures AB), eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (aktiebolag)

nach  schwedischem  Recht,  eingetragen  im  Gesellschaftsregister  in  Schweden  (Bolagsverket),  unter  der  Nummer
556815-4958, mit Sitz in Skeppsbron 18, 10313 Stockholm, Schweden,

Inhaberin von eintausendachthundertsieben (1.807) Anteilen der Serie A1b, einhundertneun (109) Anteilen der Serie

A1c und achthundertachtundzwanzig (828) Anteilen der Serie A2b der Gesellschaft,

hier vertreten durch Frau Antje Reibold, Rechtsanwältin, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom

30. Juli 2014, ausgestellt in Stockholm, Schweden,

3. Bambino 53. V V UG (haftungsbeschränkt), eine Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) nach deutschem

Recht, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland, unter der Nummer HRB 126893
B, mit Sitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Deutschland,

151473

L

U X E M B O U R G

Inhaberin von einhundertfünf (105) Stammanteilen der Gesellschaft,
hier vertreten durch Frau Antje Reibold, Rechtsanwältin geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom

29. Juli 2014, ausgestellt in Berlin, Deutschland,

4. Al European Holdings S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) gegründet

und bestehend nach dem Recht des Großherzogtum Luxemburgs, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesell-
schaftsregister (Registre de Commerce et des Sociétés), unter der Nummer B 168.122, mit Sitz in 15-17, avenue Gaston
Diderich, L-1420 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,

Inhaberin von achthundertachtundzwanzig (828) Anteilen der Serie A2b der Gesellschaft,
hier vertreten durch Frau Antje Reibold, Rechtsanwältin, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht,

ausgestellt in London, Vereinigtes Königreich, am 30. Juli 2014, und in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, am 30.
Juli 2014,

5. Aismare Lux Holdings S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) gegründet

und bestehend nach dem Recht des Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesell-
schaftsregister  (Registre  de  Commerce  et  des  Sociétés),  unter  der  Nummer  B  176544,  mit  Sitz  in  6C,  rue  Gabriel
Lippmann, L-5365 Munsbach, Großherzogtum Luxemburg, und mit einem Gesellschaftskapital von dreiundvierzigtausend
Euro (EUR 43.000), Inhaberin von dreitausendsiebenhundertfünfzig (3.750) Anteilen der Serie B1 und siebenhundertvie-
runddreißig (734) Anteilen der Serie B5 der Gesellschaft,

hier vertreten durch Frau Antje Reibold, Rechtsanwältin, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom

6. August 2014, ausgestellt in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,

6. Phenomen Ventures LP, eine exempted Limited Partnership gegründet und bestehend nach dem Recht der Kai-

maninseln (Cayman Islands), mit der Eintragungsnummer OG - 66003, mit Sitz in 89 Nexus Way, Camana Bay, Grand
Cayman  KY1-9007,  Cayman  Islands,  vertreten  durch  ihren  unbeschränkt  haftenden  Gesellschafter  (General  Partner)
Phenomen Ventures Management, eine Gesellschaft gegründet und bestehend nach dem Recht der Kaimaninseln, einge-
tragen im Registry of Companies, Cayman Islands, unter der Nummer OG-271195, mit Sitz in 89 Nexus Way, Camana
Bay, Grand Cayman KY1-9007, Cayman Islands,

Inhaberin  von  viertausendsechshundertsiebenundachtzig  (4.687)  Anteilen  der  Serie  B2  und  eintausenddreihunder-

tachtunddreißig (1.338) Anteilen der Serie B4 der Gesellschaft,

hier vertreten durch Frau Antje Reibold, Rechtsanwältin, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom

4. August 2014, ausgestellt in Moskau, am 4. August 2014,

7. Mercura Capital GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach deutschem Recht mit satzungsmäßigem

Sitz in Starnberg, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München, unter der Nummer HRB
200948, mit Geschäftssitz in Schließstättstraße 22, 82319 Starnberg, Deutschland,

Inhaberin von eintausendachthundertfünfundsiebzig (1.875) Anteilen der Serie B3 und eintausendzweihundertfünfzig

(1.250) Anteilen der Serie B4 der Gesellschaft,

hier vertreten durch Frau Antje Reibold, Rechtsanwältin, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom

29. Juli 2014, ausgestellt in Starnberg, Deutschland,

8.  Luxor  Capital  Partners,  LP,  eine  exempted  Limited  Partnership  gegründet  und  bestehend  nach  dem  Recht  des

Bundesstaates Delaware, mit Sitz in 1114 Avenue of Americas, 29 

th

 Floor, New York, NY 10036 und eingetragen im

Secretary of State of the State of Delaware unter der Eintragungsnummer 3470427, vertreten durch ihren unbeschränkt
haftenden  Gesellschafter  (General  Partner)  LCG  Holdings,  LLC,  eine  Gesellschaft  mit  beschränkter  Haftung  (limited
liability company) gegründet und bestehend nach dem Recht des Bundesstaates Delaware, eingetragen im Secretary of
State of the State of Delaware, mit Sitz in 1114 Avenue of Americas, 29 

th

 Floor, New York, NY 10036,

Inhaberin von zweitausendfünfhundertachtundneunzig (2.598) Anteilen der Serie B4 und tausendfünfhundertsechsun-

dachtzig (1.586) Anteilen der Serie B5, und wird zum Inhaber von zweitausendvierhunderteinundsiebzig (2.471) Anteilen
der Serie c der Gesellschaft,

hier vertreten durch Frau Antje Reibold, Rechtsanwältin geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom

30. Juli 2014, ausgestellt in New York, Vereinigte Staaten von Amerika,

9. Luxor Capital Partners Offshore Master Fund, LP, eine exempted Limited Partnership gegründet und bestehend

nach dem Recht der Kaimaninseln (Cayman Islands), mit Sitz in 1114 Avenue of the Americas, 29 

th

 Floor, New York,

NY 10036, USA, vertreten durch ihren unbeschränkt haftenden Gesellschafter (General Partner) LCG Holdings, LLC,
eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (limited liability company) gegründet und bestehend nach dem Recht des
Bundesstaates Delaware, eingetragen im Secretary of State of the State of Delaware, mit Sitz in 1114 Avenue of Americas,
29 

th

 Floor, New York, NY 10036, Inhaberin von viertausendachtundsiebzig (4.078) Anteilen der Serie B4 und fünfhun-

dertachtundneunzig (598) Anteilen der Serie B5, und wird zum

Inhaber von zweitausendsiebenhundertvierundachtzig (2.784) Anteilen der Serie c der Gesellschaft,
hier vertreten durch Frau Antje Reibold, Rechtsanwältin, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom

30. Juli 2014, ausgestellt in New York, Vereinigte Staaten von Amerika, und

151474

L

U X E M B O U R G

10. Luxor Wavefront, LP, eine exempted Limited Partnership gegründet und bestehend nach dem Recht des Bundes-

staates  Delaware,  mit  Sitz  in  1114  Avenue  of  Americas,  29 

th

  Floor,  New  York,  NY  10036,  vertreten  durch  ihren

unbeschränkt haftenden Gesellschafter (General Partner) LCG Holdings, LLC, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung
(limited liability company) gegründet und bestehend nach dem Recht des Bundesstaates Delaware, eingetragen im Sec-
retary of State of the State of Delaware, mit Sitz in 1114 Avenue of Americas, 29 

th

 Floor, New York, NY 10036,

Inhaberin von achthundertvierundzwanzig (824) Anteilen der Serie B4 und hunderteinundvierzig (141) Anteilen der

Serie B5, und wird zum Inhaber von fünfhundertachtunddreißig (538) Anteilen der Serie c der Gesellschaft,

hier vertreten durch Frau Antje Reibold, Rechtsanwältin, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom

30. Juli 2014, ausgestellt in New York, Vereinigte Staaten von Amerika.

11. FEC Lux S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), gegründet und be-

stehend nach dem Recht des Großherzogtum Luxemburgs, eingetragen im Luxemburger Gesellschafts- und Handelsre-
gister (Registre de Commerce et des Sociétés) unter der Nummer B 173487, mit Sitz in 2-8, avenue Charles de Gaulle,
L-1653 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg (nachfolgend „FEC“), ausschließlich für die Punkte 4 ff. der Tagesordnung
teilnahme- und stimmberechtigt,

zukünftiger Inhaber von zweitausendsechshundertneunundsiebzig (2.679) Anteilen der Serie C der Gesellschaft,
hier vertreten durch Frau Antje Reibold, Rechtsanwältin, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom

6. August 2014, ausgestellt in Luxemburg,

Besagte Vollmachten, welche von der Bevollmächtigten der erschienenen Parteien und dem unterzeichnenden Notar

ne varietur paraphiert wurden, werden der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.

Die Parteien 1 bis 10 (die „Bestehenden Gesellschafter“) sind alle Gesellschafter der Emerging Markets Online Food

Delivery Holding S.à r.l. (die „Gesellschaft”), einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée),
gegründet und bestehend nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 7, avenue J.P. Pescatore, L-2324
Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 175.738, gegründet
am 28. Februar 2013 gemäß einer Urkunde des Notars Jean-Joseph Wagner, welche am 22. April 2013 im Memorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 956 veröffentlicht wurde. Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt am
10. Juni 2014 gemäß einer Urkunde des Notars Henri Hellinckx geändert, welche noch nicht im Memorial C, Recueil des
Sociétés et Associations veröffentlicht wurde.

Da die Bestehenden Gesellschafter das gesamte Gesellschaftskapital vertreten und auf jegliche Ladungsformalitäten

verzichtet haben, ist die Gesellschafterversammlung ordnungsgemäß zusammengekommen und kann wirksam über die
folgende Tagesordnung verhandeln:

<i>Tagesordnung

1. Beschluss bezüglich der Schaffung einer (1) weiteren Klasse von Anteilen, die als Anteile der Serie C bezeichnet

werden (die „Anteile der Serie C“), wodurch nunmehr insgesamt zwölf (12) Anteilsklassen bestehen.

2. Aufnahme von FEC Lux S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), ge-

gründet und bestehend nach dem Recht des Großherzogtum Luxemburgs, eingetragen im Luxemburger Gesellschafts-
und Handelsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) unter der Nummer B 173487, mit Sitz in 2-8, avenue Charles
de Gaulle, L-1653 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, als neuer Gesellschafter der Gesellschaft.

3. Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von vierundfünfzigtausendzwei-

hundertneunzig Euro (EUR 54.290) um einen Betrag von zehntausendzweihundertzweiundachtzig Euro (EUR 10.282) auf
einen Betrag von vierundsechzigtausendfünfhundertzweiundsiebzig Euro (EUR 64.572) durch die Ausgabe von zehntau-
sendzweihundertzweiundachtzig (10.282) Anteilen der Serie C mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro
Anteil.

4. Anschließende Änderung von Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft, welcher nunmehr wie folgt lautet:

5.1.  Das  Gesellschaftskapital  der  Gesellschaft  beträgt  vierundsechzigtausendfünfhundertzweiundsiebzig  Euro  (EUR

64.572), aufgeteilt in (i) einundzwanzigtausendeinhundertfünfundsechzig (21.165) Stammanteile (die „Stammanteile”), (ii)
einhundertachtzig (180) Anteile der Serie A1a (die „Anteile der Serie A1a“), (iii) tausendachthundertsieben (1.807) Anteile
der Serie A1b (die „Anteile der Serie A1b“), (iv) einhundertneun (109) Anteile der Serie A1c (die „Anteile der Serie
A1c“), (v) dreiundachtzig (83) Anteile der Serie A2a (die „Anteile der Serie A2a“), (vi) tausendsechshundertsechsund-
fünfzig (1.656) Anteile der Serie A2b (die „Anteile der Serie A2b“), (vii) dreitausendsiebenhundertfünfzig (3.750) Anteile
der Serie B1 (die „Anteile der Serie B1“), (viii) viertausendsechshundertsiebenundachtzig (4.687) Anteile der Serie B2
(die „Anteile der Serie B2“), (ix) tausendachthundertfünfundsiebzig (1.875) Anteile der Serie B3 (die „Anteile der Serie
B3“), (x) zehntausendachtundachtzig (10.088) Anteile der Serie B4 (die „Anteile der Serie B4“) und (xi) achttausendach-
thundertneunzig (8.890) Anteile der Serie B5 (die „Anteile der Serie B5“, gemeinsam mit den Anteilen der Serie B1, den
Anteilen der Serie B2, den Anteilen der Serie B3 und den Anteilen der Serie B4, die „Anteile der Serie B“) und (xii)
zehntausendzweihundertzweiundachtzig (10.282) Anteile der Serie C (die „Anteile der Serie C“), mit einem Nominalwert
von einem Euro (EUR 1) pro Anteil.

Die mit den Anteilen verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es wird in dieser Satzung oder

durch das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.

151475

L

U X E M B O U R G

5.2. Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in

der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.

5.3. Jede der Gesellschaften (i) Rocket Internet AG, (ii) Kinnevik Online AB, (iii) Al European Holdings S.à r.l., (iv)

Aismare Lux Holdings S.à r.l., (v) Phenomen Ventures LP, (vi) Mercura Capital GmbH, (vii) Luxor Capital Partners, LP,
Luxor Capital Partners Offshore Master Fund, LP und Luxor Wavefront, LP (gemeinschaftlich „LuxorCap“) (Luxor Capital
Partners, LP, Luxor Capital Partners Offshore Master Fund, LP und Luxor Wavefront, LP üben ihre Rechte unter dieser
Satzung gemeinschaftlich aus, als ob es sich um einen einzigen Gesellschafter handeln würde; Luxor Capital Partners, LP
selbst ist dazu berechtigt, sämtliche Erklärungen im Namen von LuxorCap abzugeben und entgegenzunehmen, Luxor
Capital Partners Offshore Master Fund, LP und Luxor Wavefront, LP bezüglich Rechten und Pflichten, die sich aus von
ihnen gehaltenen Anteilen ergeben) und (viii) FEC Lux S.à r.l. ist zur Zeichnung einer Anzahl weiterer bei einer Kapital-
erhöhung ausgegebenen Anteile berechtigt, wodurch ein Investmentangebot eines Dritten umgesetzt wird (bei dem es
sich weder um einen Gesellschafter, noch um eine mit einem Gesellschafter verbundene Gesellschaft im Sinne der §§ 15
ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG) (ein „Drittinvestor“) handelt), und der vom Beirat zugestimmt wurde (eine
„Investition eines Dritten“) - unabhängig davon, ob diese vom Drittinvestor oder von einem oder mehreren vergleich-
baren Gesellschaftern erfolgte - die zur Erhaltung der Beteiligungsquote an der Gesellschaft vor einer solchen Kapitaler-
höhung erforderlich ist, und dies zu denselben Bedingungen, wie bei einer Investition eines Dritten. (i) Rocket Internet
AG, (ii) Kinnevik Online AB, (iii) Al European Holdings S.à r.l., (iv) Aismare Lux Holdings S.à r.l., (v) Phenomen Ventures
LP, (vi) Mercura Capital GmbH, (vii) LuxorCap und (viii) FEC Lux S.à r.l. haben die Gesellschaft durch eine verbindliche
Erklärung innerhalb von drei (3) Wochen, nachdem sie von der Gesellschaft über die Investition eines Dritten informiert
wurden, darüber zu unterrichten, ob Rocket Internet AG und/oder Kinnevik Online AB und/oder Al European Holdings
S.à r.l. und/oder Aismare Lux Holdings S.à r.l. und/oder Phenomen Ventures LP und/oder Mercura Capital GmbH und/
oder LuxorCap und/oder FEC Lux S.à r.l. ihr Recht gemäß des vorstehenden Satzes dieses Artikels 5.3 ausüben möchten.
Für den Fall, dass einer der Investoren weitere Anteile der Gesellschaft zeichnet, ist dieser Artikel 5.3 entsprechend
anzuwenden.“

5. Anschließende Änderung von Artikel 7.4 der Satzung der Gesellschaft, welcher nunmehr wie folgt lautet:

„ 7.4. Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern, die

mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals halten (eine „Qualifizierte Mehrheit“) und vorbehaltlich der Bestim-
mungen von Gesellschaftervereinbarungen zwischen den Gesellschaftern, sofern vorhanden, insbesondere vorbehaltlich
Vorkaufsrechten, Bezugsrechten oder Mitverkaufsrechten- oder Pflichten aus Gesellschaftervereinbarungen zwischen den
Gesellschaftern übertragen werden. Sofern eine solche Zustimmung erteilt wurde, ist eine zusätzliche Zustimmung zur
Übertragung der Anteile nicht erforderlich:

„a) bei einem Verkauf, einer Übertragung, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen durch (i)

Rocket Internet AG, (ii) Kinnevik Online AB, (iii) Al European Holdings S.à r.l., (iv) Aismare Lux Holdings S.à r.l., (v)
Phenomen Ventures LP, (vi) Mercura Capital GmbH und (vii) Luxor Capital, Luxor Offshore und Luxor Wavefront (wobei
Luxor Capital insofern in eigenem Namen sowie für Luxor Offshore und Luxor Wavefront handelt und Rechte, die sich
aus Anteilen ergeben, die von einem von ihnen gehalten werden, unter dieser Satzung gemeinschaftlich ausübt, als ob es
sich um einen einzigen Gesellschafter handeln würde) (Rocket Internet AG, Kinnevik Online AB, Al European Holdings
S.à r.l., Aismare Lux Holdings S.à r.l., Phenomen Ventures LP, Mercura Capital GmbH, Luxor Capital, Luxor Offshore,
Luxor Wavefront und FEC Lux S.à r.l. im Folgenden gemeinschaftlich die „Investoren“; jeweils einzeln ein „Investor“) an
eine mit dem betreffenden Investor verbundene Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG);

b) bei einem Verkauf, einer Übertragung, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen eines Inves-

tors an eine Gesellschaft oder ein Unternehmen, (x) welches direkt oder indirekt über (i) einen Investor oder (ii) einen
oder mehrere direkte oder indirekte kontrollierende Gesellschafter des Investors herrscht, von diesem abhängig ist, oder
unter der gemeinsamen Kontrolle von diesem steht (jeweils eine „Kontrollierte Gesellschaft“), wobei die Worte „Kon-
trolle“ oder „Abhängig“ oder „Herrscht“ die direkte oder indirekte Kontrolle der Gesellschaft bezeichnet, durch (a) die
Leitung der Gesellschaft durch einen geschäftsführenden Gesellschafter, (b) das Halten der Mehrheit der Anteile, (c) das
Halten der Mehrheit der Stimmrechte durch eine vertragliche Stimmvereinbarung, oder (d) die einseitige Fähigkeit, die
Richtung der Geschäftsleitung und Geschäftspolitik einer Person, entweder durch den Besitz von Wertpapieren oder
anderweitig zu bewirken oder (y) in welcher der Investor oder einer oder mehrere Gesellschafter des Investors eine
direkte oder indirekte Mehrheitsbeteiligung haben;

c) bei einem Verkauf, einer Übertragung, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen an einen

Dritten, welcher Anteile unter der vereinheitlichten Mitarbeiterbeteiligung erwirbt, oder von einem Gesellschafter an die
Gesellschaft und/oder einen beliebigen Investor gemäß einer Call-Option im Zusammenhang mit einer Vesting-Regelung.“

6. Anschließende Änderung von Artikel 8 der Satzung der Gesellschaft, welcher nunmehr wie folgt lautet:

„ 8.1. Im Falle (i) eines Verkaufs von mindestens fünfzig Prozent (50%) aller Anteile an der Gesellschaft oder eines

Tausches oder einer Übernahme der Gesellschaft in wirtschaftlich vergleichbarer Weise in einer oder mehreren Trans-
aktionen oder in zeitlicher Nähe zueinander, oder (ii) der Liquidation der Gesellschaft oder (iii) des Verkaufs oder der
Übertragung von Anteilen an der Gesellschaft entweder an Dritte oder an andere Gesellschafter, was dazu führen würde,
dass entweder mehr als fünfzig Prozent (50%) des Gesellschaftskapitals oder mehr als fünfzig Prozent (50%) der Stimm-

151476

L

U X E M B O U R G

rechte im Besitz der erwerbenden Partei bzw. Parteien wären (change of control), als Ergebnis eines oder mehrerer
verbundener Akquisitionen, (wobei jeder der unter (i), (ii) und (iii) beschriebenen Fälle im Folgenden als „Liquiditätser-
eignis“ bezeichnet wird), werden die Erlöse („Exiterlöse“) - vorbehaltlich der Artikel 8.2, 8.3 und 8.4 - im Einklang mit
Artikel 8.5 auf einer pro rata-Basis entsprechend ihrer Beteiligung am Liquiditätsereignis an die Gesellschafter verteilt.

8.2. Auf einer ersten Ebene („Erste Ebene“) erhalten die Inhaber von Anteilen der Serie C einen Betrag von EUR

2.762,94 pro Anteil der Serie C, welcher dem Betrag ihrer jeweiligen Gesamtinvestition in die Gesellschaft entspricht
(bestehend aus dem Nominalbetrag der von diesem Inhaber erworbenen Anteile der Serie C und dem Agio und/oder
anderen Kapitaleinlagen (Konto 115 des Standardisierten Luxemburgischen Kontenplans), die von diesem Inhaber an die
Gesellschafter gezahlt wurden).

8.3. Auf einer zweiten Ebene („Zweite Ebene”) erhalten die Inhaber von Anteilen der Serie B einen Betrag von EUR

1.600 pro Anteil der Serie B, welcher dem Betrag ihrer jeweiligen Gesamtinvestition in die Gesellschaft entspricht (be-
stehend aus dem Nominalbetrag der von diesem Inhaber erworbenen Anteile der Serie B und dem Agio und/oder anderen
Kapitaleinlagen (Konto 115 des Standardisierten Luxemburgischen Kontenplans), die von diesem Inhaber an die Gesell-
schafter gezahlt wurden).

8.4. Auf einer dritten Ebene („Dritte Ebene”) erhalten die Inhaber von Anteilen der Serie A1a, Anteilen der Serie A1b,

Anteilen der Serie A1c, Anteilen der Serie A2a und Anteilen der Serie A2b pro Anteil der entsprechenden Anteilsklasse
(und zwischen den Gesellschaftern jeder Anteilsklasse auf einer pro rata-Basis zu deren Anteilsbesitz in der entsprech-
enden Anteilsklasse) den wie folgt festgelegten Betrag:

Anteilsklasse

Betrag

pro

Anteil

in Euro

Anteil der Serie A1a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.380,84
Anteil der Serie A1b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.383,14
Anteil der Serie A1c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,00

Anteil der Serie A2a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.556,82
Anteil der Serie A2b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.554,76

8.5. Nachdem die Zahlungen auf der Ersten Ebene, auf der Zweiten Ebene und auf der Dritten Ebene geleistet wurden,

werden die übrigen Exiterlöse auf einer vierten Ebene („Vierte Ebene“) an alle Gesellschafter auf einer pro rata-Basis
entsprechend ihrer Beteiligung am Liquiditätsereignis verteilt. Sämtliche von einem Gesellschafter auf der Ersten Ebene
und/oder der Zweiten Ebene und/oder der Dritten Ebene erhaltenen Beträge mindern den von diesem Gesellschafter zu
erhaltenden Betrag auf der Vierten Ebene und werden anschließend entsprechend dieser Vierten Ebene zugeteilt, mit der
Maßgabe, dass kein Gesellschafter zur Rückzahlung eines auf der Ersten Ebene und/oder der Zweiten Ebene und/oder
der Dritten Ebene erhaltenen Betrags verpflichtet ist. Die Zuteilung auf der Vierten Ebene erfolgt solange, bis alle Exi-
terlöse an die Gesellschafter verteilt wurden. Unabhängig davon, ob der Verkauf von Anteilen während eines Liquidität-
sereignisses oder danach in einer oder mehreren Transaktionen erfolgt oder nicht, hat kein Gesellschafter für den Verkauf
all seiner Anteile einen Betrag zu erhalten, der höher ist, (i) als sein Anteil an der Gesamtheit der Exiterlöse oder Erlöse
auf einer pro rata-Basis zu den verkauften Anteilen, oder (ii) als der Betrag, der diesem Gesellschafter auf der Ersten
Ebene und/oder der Zweiten Ebene und/oder der Dritten Ebene zugeteilt wurde. Erhält ein Gesellschafter dennoch einen
höheren Betrag, muss er den Überschuss dementsprechend an die anderen Gesellschafter zurückzahlen. Sämtliche mit
der hierin festgelegten Liquiditätspräferenz verbundenen Ansprüche sind erst dann erfüllt, wenn der in Satz 1 dieses
Artikels 8.5 festgesetzter Betrag hinsichtlich der jeweiligen Anteile erhalten wurde.

8.6. Die bevorzugte Zuteilung auf der Ersten Ebene, auf der Zweiten Ebene und auf der Dritten Ebene ist auf alle

entsprechenden Anteile der Serie C, Anteile der Serie B, Anteile der Serie A1a, Anteile der Serie A1b, Anteile der Serie
A1c, Anteile der Serie A2a und Anteile der Serie A2b anwendbar, solange bei den jeweiligen Anteile der Serie C, Anteile
der Serie B, Anteilen der Serie A1a, Anteilen der Serie A1b, Anteilen der Serie A1c, Anteilen der Serie A2a und Anteilen
der Serie A2b der in Artikel 8.2 und/oder der in der Tabelle in Artikel 8.4 festgelegte Betrag noch nicht verteilt wurde.“

7. Anschließende Änderung von Artikel 17.1 der Satzung der Gesellschaft, welcher nunmehr wie folgt lautet:

„ 17.1. Beschlüsse hinsichtlich der folgenden Angelegenheiten erfordern eine Qualifizierte Mehrheit und jede dieser

Maßnahmen erfordert die Zustimmung des Beirats:

a) Veräußerung des gesamten Gesellschaftsvermögens, eines beträchtlichen Anteils des Gesellschaftsvermögens oder

des gesamten oder eines beträchtlichen Anteils des Vermögens direkter oder indirekter Tochtergesellschaften der Ge-
sellschaft einschließlich des Beschlusses hinsichtlich der Abwicklung der Gesellschaft;

b) Veräußerung von Anteilen in direkten oder indirekten Tochtergesellschaften der Gesellschaft, mit Ausnahme von

Anteilsübertragungen unter der vereinheitlichten Mitarbeiterbeteiligung, wie von den Gesellschafter in einer Gesellschaf-
tervereinbarung vereinbart;

151477

L

U X E M B O U R G

c) Änderung dieser Satzung (einschließlich des vorliegenden Artikels 17) einschließlich des Beschlusses hinsichtlich der

Verschmelzung, Spaltung und Umwandlung der Gesellschaft;

d) Verwendung des Jahresergebnisses; Zahlungen von Gewinnen in Kapitalreserven oder der Gewinnvortrag solcher

Gewinne auf neue Rechnung: Erhöhung oder Herabsetzung (ausschüttbarer) Reserven (einschließlich, aber nicht begrenzt
auf das Agio und andere Kapitalreserven), sowie Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln; Zahlung von Abschlagsdivid-
enden; Zahlung von Erlösen gemäß Artikel 8 („Liquidations- und Verkaufspräferenzen“);

e) Abschluss von Unternehmensverträgen (im Sinne der §§ 291 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG));
f) Abschluss von Unternehmensbeteiligungen jeglicher Art, einschließlich stiller Gesellschaften und sämtlicher Verträge,

durch welche die andere Vertragspartei eine Beteiligung am Gewinn der Gesellschaft erhält oder jede Zahlung, welche
vom Gewinnbetrag der Gesellschaft abhängig ist; dies umfasst nicht Verträge unter der durch die Gesellschafter in einer
Gesellschaftervereinbarung festgesetzten vereinheitlichten Mitarbeiterbeteiligung;

g) Genehmigung des Jahresplans, insbesondere des Haushaltsplans für jedes folgende Jahr und des Jahresabschlusses;
h) Abberufung und Ernennung von Geschäftsführern.“
8. Anschließende Änderung von Artikel 17.2 der Satzung der Gesellschaft, welcher nunmehr wie folgt lautet:

„ 17.2. Beschlüsse hinsichtlich der folgenden Angelegenheiten erfordern eine Qualifizierte Mehrheit und jede dieser

Maßnahmen erfordertdie Zustimmung aller Investoren:

a) Ausschluss von Bezugsrechten im Falle von Kapitalerhöhungen;
b) Erwerb eigener Anteile der Gesellschaft, einschließlich des Rückkaufs von Anteilen mit Ausnahme der Erwerbe

gemäß Artikel 9.2 und Übertragungen gemäß Artikel 11.1 dieser Satzung.“

9. Anschließende Änderung von Artikel 22.8 der Satzung der Gesellschaft, welcher nunmehr wie folgt lautet:

„ 22.8. Die Geschäftsführer benötigen die Zustimmung des Beirats für die untenstehenden Rechtsgeschäfte und Maß-

nahmen der Gesellschaft und deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften. Eine Zustimmung ist nicht erfor-
derlich,  sofern  solche  Rechtsgeschäfte  und  Maßnahmen  präzise  definiert  und  im  Voraus  von  einem  bewilligten
Haushaltsplan mit der Zustimmung der Gesellschafterversammlung genehmigt wurden:

a) Gründung, Erwerb oder Veräußerung von Gesellschaften, Unternehmen oder Teilbetrieben;
b) Änderung der Satzung, Gesellschaftervereinbarungen und ähnlicher Verträge sowie die Ausübung (oder der Aus-

schluss) von Gesellschafterrechten bei Gesellschaften, in denen eine direkte oder indirekte Beteiligung gehalten wird
(vorausgesetzt, dass die Geschäftsführer bezüglich Gesellschaften, in denen nur eine indirekte Beteiligung gehalten wird,
sicherstellen, dass solche Zustimmungserfordernisse von dem jeweiligen direkten Gesellschafter eingehalten wurde);

c) Erwerb, Verkauf und Belastung von Immobilien und ähnlicher Rechte oder Rechte an Immobilien;
d) Wesentliche Änderungen der Art der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und Einstellung eines wesentlichen Ge-

schäftsbetriebs;

e) Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder ähnlichen Verpflichtungen, die einen Gesamtbetrag von zweihun-

derttausend Euro (EUR 200.000) überschreiten;

f) Gewährung von Darlehen, die einen Gesamtbetrag von zweihunderttausend Euro (EUR 200.000) überschreiten,

unter Ausschluss von Darlehen zwischen der Gesellschaft und direkten oder indirekten Tochtergesellschaften der Ge-
sellschaft;

g) Abschluss und Kündigung von Kredit- und Darlehensverträgen und anderen Finanzverträgen, die einen Gesamtbetrag

von zweihunderttausend Euro (EUR 200.000) überschreiten und Änderungen des Kreditrahmens, unter Ausschluss von
Verträgen zwischen der Gesellschaft und direkten oder indirekten Tochtergesellschaften der Gesellschaft;

h) Termingeschäfte über Devisen, Sicherheiten und börsengehandelte Waren und Rechte, sowie weitere Transaktio-

nen mit derivaten Finanzinstrumenten;

i) Gewährung, Einführung und Änderung von Versorgungsverpflichtungen jeglicher Art;
j) Abschluss, Änderung oder Kündigung von Unternehmenstarifverträgen, Betriebsvereinbarungen (von erheblicher

Bedeutung) und allgemeiner Richtlinien hinsichtlich der betrieblichen Altersvorsorge der Gesellschaft;

k) Einleitung oder Beendigung von Rechtsstreitigkeiten, insbesondere Schiedsgerichtsverfahren mit einem Streitwert

von über zehntausend Euro (EUR 10.000) im Einzelfall;

l) Verfügung über Nutzungsrechte jeglicher Art hinsichtlich der Rechte an geistigem Eigentum, einschließlich Urhe-

berrechte oder sämtliche weiteren Schutzrechte sowie die Weitergabe von Know-how zur eigenen Verwertung durch
die Firma und/oder Drittparteien, unter Ausschluss von Verfügungen zwischen der Gesellschaft und direkten und indi-
rekten Tochtergesellschaften der Gesellschaft;

m) Transaktionen zwischen (i) auf der einen Seite die Gesellschaft und ihren affiliierten Gesellschaften und (ii) auf der

anderen Seite Gesellschafter der Gesellschaftund/oder ihre Affiliierten;

n) Änderungen an und Kündigung von Unternehmensverträgen (im Sinne der §§ 291 ff. des deutschen Aktiengesetzes

(AktG));

151478

L

U X E M B O U R G

o) Ausübung von Stimmrechten und anderen Rechten in einer Gesellschaft, deren Gesellschafter die Gesellschaft ist,

sofern diese Ausübung die Zustimmung der Gesellschafterversammlung nach dieser Satzung erfordert, d.h. gemäß dieses
Artikels 22.8, a) bis o), Artikel 17.1 oder 17.2.

Beschlüsse bezüglich der Einführung eines Mitarbeiter-Beteiligungsmodells bedürfen der Zustimmung des Beirats.“
10. Anschließende Änderung von Artikel 25.1 der Satzung der Gesellschaft, welcher nunmehr wie folgt lautet:

„ 25.1. Die Gesellschaft hat einen Beirat (der „Beirat“). Dieser besteht aus acht (8) stimmberechtigte Mitglieder. Die

Gesellschafterversammlung kann durch einen einstimmigen Gesellschafterbeschluss die Anzahl der Mitglieder des Beirats
erhöhen oder herabsetzen. Jeder Gesellschafter kann ein nicht stimmberechtigtes Mitglied des Beirats ernennen.“

11. Anschließende Änderung von Artikel 25.3 der Satzung der Gesellschaft, welcher nunmehr wie folgt lautet:

25.3. Die stimmberechtigten Mitglieder des Beirats werden von den Gesellschaftern durch schriftliche Mitteilung an

die Gesellschaft wie folgt ernannt:

a) ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats wird von dem Gesellschafter Rocket Internet AG nach eigenem

Ermessen ernannt (das „Rocket-Mitglied“);

b) ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats wird von dem Gesellschafter Kinnevik Online AB nach eigenem

Ermessen ernannt;

c) ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats wird von dem Gesellschafter AI European Holdings S.à r.l. nach

eigenem Ermessen ernannt;

d) ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats wird von dem Gesellschafter Aismare Lux Holdings S.à r.l. nach

eigenem Ermessen ernannt;

e) ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats wird von dem Gesellschafter Phenomen Ventures LP nach eigenem

Ermessen ernannt;

f) ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats wird von dem Gesellschafter Mercura Capital GmbH nach eigenem

Ermessen ernannt;

g) ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats wird von den Gesellschaftern LuxorCap nach eigenem Ermessen

ernannt; und

h) ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats wird von dem Gesellschafter FEC Lux S.à r.l. nach eigenem Ermessen

ernannt.

12. Anschließende Änderung von Artikel 25.4 der Satzung der Gesellschaft, welcher nunmehr wie folgt lautet:
„Der Beirat hat einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden. Das Rocket-Mitglied ist der Vorsitzende

des Beirats und hat nicht die entscheidende Stimme. Jedes stimmberechtigte Mitglied hat eine (1) Stimme, außer das von
Rocket ernannte stimmberechtigte Mitglied, welches fünf (5) Stimmen hat, das von LuxorCap ernannte stimmberechtigte
Mitglied, welches drei (3) Stimmen hat und das von Kinnevik ernannte stimmberechtigte Mitglied, welches zwei (2) Stim-
men hat. Die Geschäftsordnung des Beirats hat weitere Bestimmungen, insbesondere hinsichtlich der Selbstorganisation
des Beirats, zu enthalten.“

13. Verschiedenes
Nach ordnungsgemäßer Beratung über jeden Tagesordnungspunkt fasst die Gesellschafterversammlung einstimmig die

folgenden Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschaftversammlung beschließt eine (1) weitere Klasse von Anteilen zu schaffen, die als Anteile der Serie C

bezeichnet werden (die „Anteile der Serie C“), wodurch nunmehr insgesamt zwölf (12) Anteilsklassen bestehen.

<i>Zweiter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt FEC als neuen Gesellschafter der Gesellschaft aufzunehmen.

<i>Dritter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt die Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft von seinem der-

zeitigen  Betrag  von  vierundfünfzigtausendzweihundertneunzig  Euro  (EUR  54.290)  um  einen  Betrag  von  zehntausend-
zweihundertzweiundachtzig Euro (EUR 10.282) auf einen Betrag von vierundsechzigtausendfünfhundertzweiundsiebzig
Euro (EUR 64.572) durch die Ausgabe von zehntausendzweihundertzweiundachtzig (10.282) Anteilen der Serie C mit
einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Anteil und die anschließende Änderung des Artikel 5 der Satzung der
Gesellschaft, welcher nunmehr wie es in der Tagesordnung des gegenwärtigen Aktes aufgeführt ist lautet.

<i>Zeichnung

- Tausendachthundertzehn (1.810) Anteile der Serie C wurden ordnungsgemäß von Rocket Internet AG, vorbenannt,

für einen Preis von Tausendachthundertzehn Euro (1.810) gezeichnet;

- Zweitausendvierhunderteinundsiebzig (2.471) Anteile der Serie C wurden ordnungsgemäß von Luxor Capital Part-

ners LP, vorbenannt, für einen Preis von zweitausendvierhunderteinundsiebzig Euro (EUR 2.471) gezeichnet;

151479

L

U X E M B O U R G

- Zweitausendsiebenhundertvierundachtzig (2.784) Anteile der Serie C wurden ordnungsgemäß von Luxor Capital

Partners Offshore Master Fund LP, vorbenannt, für einen Preis von zweitausendsiebenhundertvierundachtzig Euro (EUR
2.784) gezeichnet:

- Fünfhundertachtunddreißig (538) Anteile der Serie C wurden ordnungsgemäß von Luxor Wavefront LP, vorbenannt,

für einen Preis von fünfhundertachtunddreißig Euro (EUR 538) gezeichnet; und

- Zweitausendsechshundertneunundsiebzig (2.679) Anteile der Serie C wurden ordnungsgemäß von FEC, vorbenannt,

für einen Preis von zweitausendsechshundertneunundsiebzig Euro gezeichnet.

<i>Zahlung

Die tausendachthundertzehn (1.810) von Rocket Internet AG, vorbenannt, die zweitausendvierhunderteinundsiebzig

(2.471) von Luxor Capital Partners LP, vorbenannt, die zweitausendsiebenhundertvierundachtzig (2.784) von Luxor Ca-
pital Partners Offshore Master Fund LP, vorbenannt, die fünf hundertachtunddreißig (538) von Luxor Wavefront LP,
vorbenannt  und  die  zweitausendsechshundertneunundsiebzig  (2.679)  von  FEC,  vorbenannt,  gezeichneten  Anteile  der
Serie C wurden vollständig durch eine Bareinlage in Höhe von zehntausendzweihundertzweiundachtzig Euro (EUR 10.282)
eingezahlt.

Der Nachweis über die Existenz und den Wert der oben bezeichneten Einlage wurde dem unterzeichnenden Notar

erbracht.

Die Einlage in Höhe von zehntausendzweihundertzweiundachtzig Euro (EUR 10.282) wird vollständig dem Gesell-

schaftskapital zugeführt.

<i>Vierter Beschluss

Die Generalversammlung erkennt an, dass FEC nun Inhaber von zweitausendsechshundertneunundsiebzig (2.679) An-

teilen der Serie C der Gesellschaft geworden ist.

Demzufolge  schließt  sich  FEC,  stimmberechtigt  und  hier  vertreten  durch  Frau  Antje  Reibold,  Rechtsanwältin,  ge-

schäftsansässig in Luxemburg, auf Grund der vorbenannten Vollmacht, der Gesellschafterversammlung an um über die
folgenden Punkte der Tagesordnung abzustimmen.

<i>Fünfter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt die Änderung des Artikel 7.4a der Satzung der Gesellschaft, welcher nun-

mehr wie es in der Tagesordnung des gegenwärtigen Aktes aufgeführt ist lautet.

<i>Sechster Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt die Änderung des Artikel 8 der Satzung der Gesellschaft, welcher nunmehr

wie es in der Tagesordnung des gegenwärtigen Aktes aufgeführt ist lautet.

<i>Siebter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt die Änderung des Artikel 17.1 der Satzung der Gesellschaft, welcher nun-

mehr wie es in der Tagesordnung des gegenwärtigen Aktes aufgeführt ist lautet.

<i>Achter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt die Änderung des Artikel 17.2 der Satzung der Gesellschaft, welcher nun-

mehr wie es in der Tagesordnung des gegenwärtigen Aktes aufgeführt ist lautet.

<i>Neunter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt die Änderung des Artikel 22.8 der Satzung der Gesellschaft, welcher nun-

mehr wie es in der Tagesordnung des gegenwärtigen Aktes aufgeführt ist lautet.

<i>Zehnter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt die Änderung des Artikel 25.1 der Satzung der Gesellschaft, welcher nun-

mehr wie es in der Tagesordnung des gegenwärtigen Aktes aufgeführt ist lautet.

<i>Elfter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt die Änderung des Artikel 25.3 der Satzung der Gesellschaft, welcher nun-

mehr wie es in der Tagesordnung des gegenwärtigen Aktes aufgeführt ist lautet.

<i>Zwölfter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt die Änderung des Artikel 25.4 der Satzung der Gesellschaft, welcher nun-

mehr wie es in der Tagesordnung des gegenwärtigen Aktes aufgeführt ist lautet.

Da die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung geschlossen.

151480

L

U X E M B O U R G

<i>Kosten und Auslagen

Die Kosten, Auslagen, Honorare und Gebühren jeglicher Art, die von der Gesellschaft zu tragen sind, werden auf

ungefähr EUR 2.500.- geschätzt.

Hierüber wurde diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen.
Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache beherrscht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende

Urkunde auf Verlangen der erschienenen Parteien auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung;
auf Verlangen besagter erschienener Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen
Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.

Die vorstehende Urkunde ist der Bevollmächtigten der erschienenen Parteien, welche dem Notar mit Namen, Vorn-

amen und Wohnsitz bekannt ist, verlesen und vom Notar gemeinsam mit dieser Bevollmächtigten unterzeichnet worden.

Gezeichnet: A. REIBOLD und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 22 août 2014. Relation: LAC/2014/39421. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur

 (signé): I. THILL.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - Der Gesellschaft auf Begehr erteilt.

Luxemburg, den 15. September 2014.

Référence de publication: 2014144744/846.
(140164527) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2014.

Willis Lux Holdings 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.000.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 182.254.

In the year two thousand and fourteen, on the eight day of the month of August;
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

was held

an extraordinary general meeting of the shareholders of Willis Lux Holdings 2 S.à r.l., (the “Company”) a société à

responsabilité limitée, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Lu-
xembourg, being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés of Luxembourg under number B182.254.
The Company was incorporated by deed of Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, on 29 November
2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the “Mémorial”) number 142 on 16 January
2014. The articles of association of the Company have been amended for the last time by deed of the undersigned notary
on 14 February 2014 published in the Mémorial number 1267 on 17 May 2014.

The meeting was presided by Maître Alexandre Pel, attorney-at-law, residing in Luxembourg.
There was appointed as secretary and scrutineer Maître Nora Filali, attorney-at-law, residing in Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to state that:
1. The shareholders represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list

signed by the proxyholder, the chairman, the secretary and scrutineer and the undersigned notary, which will be attached
to the present deed to be filed with the registration authorities.

As it appeared from said attendance list, all ninety-three thousand three hundred twenty thousand eight hundred ninety

(93,320,890) shares in issue in the Company were represented at the general meeting and the shareholders of the Com-
pany declared that they had prior knowledge of the agenda so that the meeting was validly constituted and able to validly
decide on all the items of the agenda.

2. The agenda of the meeting was as follows:
Increase of the issued share capital of the Company by an amount of sixty-six thousand seven hundred ninety-one

Euro and ten Euro cents (EUR66,791.10) from nine hundred and thirty three thousand two hundred and eight Euro and
ninety cents (EUR933,208.90) to one million Euro (EUR1,000,000) by the issue of a total of six million six hundred seventy-
nine thousand one hundred and ten (6,679,110) shares in such classes as set forth below with a nominal value of one
Euro cent (EUR0.01) each (the “New Shares”), subscription to the New Shares by the subscribers pursuant to the exercise
of warrants issued by the Company in such proportions as set forth below;

Subscribers

Class of

shares

Number

of shares

BX Cayco 1 (2014) Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ordinary

666,241

BX Cayco 2 (2014) Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ordinary

1,670

Total ordinary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

667,911

151481

L

U X E M B O U R G

BX Cayco 1 (2014) Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A

666,241

BX Cayco 2 (2014) Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A

1,670

Total class A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

667,911

BX Cayco 1 (2014) Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B

666,241

BX Cayco 2 (2014) Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B

1,670

Total class B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

667,911

BX Cayco 1 (2014) Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C

666,241

BX Cayco 2 (2014) Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C

1,670

Total class C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

667,911

BX Cayco 1 (2014) Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D

666,241

BX Cayco 2 (2014) Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D

1,670

Total class D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

667,911

BX Cayco 1 (2014) Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E

666,241

BX Cayco 2 (2014) Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E

1,670

Total class E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

667,911

BX Cayco 1 (2014) Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

F

666,241

BX Cayco 2 (2014) Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

F

1,670

Total class F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

667,911

BX Cayco 1 (2014) Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

G

666,241

BX Cayco 2 (2014) Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

G

1,670

Total class G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

667,911

BX Cayco 1 (2014) Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

H

666,241

BX Cayco 2 (2014) Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

H

1,670

Total class H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

667,911

BX Cayco 1 (2014) Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I

666,241

BX Cayco 2 (2014) Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I

1,670

Total class I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

667,911

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,679,110

Amendment of Article 8.1. of the articles of association of the Company to be read as follows:

“ Art. 8.1. The issued share capital of the Company is set at one million Euro (EUR1,000,000) divided into:
- ten million (10,000,000) Ordinary Shares,
- ten million (10,000,000) Class A Shares,
- ten million (10,000,000) Class B Shares,
- en million (10,000,000) Class C Shares,
- ten million (10,000,000) Class D Shares,
- ten million (10,000,000) Class E Shares,
- ten million (10,000,000) Class F Shares,
- ten million (10,000,000) Class G Shares,
- ten million (10,000,000) Class H Shares, and
- ten million (10,000,000) Class I Shares,
each Share having a nominal value of one Euro Cent (EUR0.01) and the rights and obligations as set forth in the present

Articles.”.

After deliberation the meeting unanimously resolved as follows:

<i>Sole resolution

The meeting unanimously resolved to increase the issued share capital of the Company by an amount of sixty-six

thousand seven hundred and ninety-one Euro and ten Euro cents (EUR66,791.10) from nine hundred and thirty three
thousand two hundred and eight Euro and ninety Euro cents (EUR933,208.90) to one million Euro (EUR1,000,000) by
the issue of a total of six million six hundred and seventy-nine thousand one hundred and ten (6,679,110) shares in such
classes as set forth in the agenda with a nominal value of one Euro cent (EUR0.01) each (the “New Shares”).

The Subscribers each represented by Me Alexandre Pel, prenamed, subscribed to the New Shares so issued in the

proportions as set forth in the agenda pursuant to the exercise of warrants issued by the Company.

Evidence of the payment of the issue price was shown to the notary.

151482

L

U X E M B O U R G

As a result of the above resolution, the meeting unanimously resolved to amend Article 8.1. of the articles of association

of the Company as set out in the agenda.

Nothing further being on the agenda, the meeting was thereupon closed.

<i>Expenses

The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at two thousand Euros (2,000.- EUR).

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that of the request of the party hereto,

these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person in case
of divergences between the English and French version, the English version will be prevailing.

Done in Luxembourg, on the day beforementionned.
After reading these minutes the proxyholder signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L’an deux mille quatorze, le huitième jour du mois d’août;
Pardevant nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

S’est tenue

une assemblée générale extraordinaire des associés de Willis Lux Holdings 2 S.à r.l., (la «Société») une société à

responsabilité limitée, dont le siège social est situé au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, étant immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B182.254. La Société a été constituée le 29 novembre 2013 suivant acte reçu de Maître Joseph Elvinger, notaire de
résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 142 du 16
janvier 2014. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois le 14 février 2014 par acte du notaire soussigné,
publié au Mémorial numéro 1267 du 17 mai 2014.

L’assemblée a été présidée par Maître Alexandre Pel, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
A été nommé comme secrétaire et scrutateur Maître Nora Filali, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
Le président a déclaré et requis le notaire d’acter que:
1. Les associés représentés ainsi que le nombre de parts sociales que chacun détient figurent sur une liste de présence

signée par les mandataires, le président, le secrétaire et scrutateur, et le notaire soussigné, laquelle sera annexée au
présent acte afin d’être soumise aux formalités de l’enregistrement.

Tel qu'il appert de ladite liste de présence, l’ensemble des quatre-vingt-treize millions trois cent vingt mille huit cent

quatre-vingt-dix (93.320.890) parts sociales émises dans la Société étaient représentées à l’assemblée générale et les
associés de la Société ont déclaré avoir eu connaissance de l’ordre du jour au préalable de sorte que l’assemblée était
valablement constituée et en mesure de décider valablement de l’ensemble des points portés à l’ordre du jour.

2. L’ordre du jour de l’assemblée était le suivant:
Augmentation du capital social émis de la Société d’un montant de soixante-six mille sept cent quatre-vingt-onze euros

et dix centimes (66.791,10 EUR) afin de le porter de son montant actuel de neuf cent trente-trois mille deux cent huit
euros et quatre-vingt-dix centimes (933.208,90 EUR) à un million d’euros (1.000.000 EUR) par l’émission d’un total de
six millions six cent soixante-dix-neuf mille cent dix (6.679.110) parts sociales parmi les classes indiquées ci-dessous d’une
valeur nominale d’un centime d’euro (0,01 EUR) chacune (les «Nouvelles Parts Sociales»), souscription des Nouvelles
Parts Sociales par les souscripteurs suivant l’exercice de warrants émis par la Société dans les proportions indiquées ci-
dessous;

Souscripteurs

Classe

de parts

sociales

Nombre

de parts

sociales

BX Cayco 1 (2014) Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ordinaire

666.241

BX Cayco 2 (2014) Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ordinaire

1.670

Total ordinaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

667.911

BX Cayco 1 (2014) Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A

666.241

BX Cayco 2 (2014) Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A

1.670

Total classe A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

667.911

BX Cayco 1 (2014) Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B

666.241

BX Cayco 2 (2014) Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B

1.670

Total classe B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

667.911

BX Cayco 1 (2014) Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C

666.241

BX Cayco 2 (2014) Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C

1.670

Total classe C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

667.911

151483

L

U X E M B O U R G

BX Cayco 1 (2014) Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D

666.241

BX Cayco 2 (2014) Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D

1.670

Total classe D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

667.911

BX Cayco 1 (2014) Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E

666.241

BX Cayco 2 (2014) Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E

1.670

Total classe E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

667.911

BX Cayco 1 (2014) Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

F

666.241

BX Cayco 2 (2014) Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

F

1.670

Total classe F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

667.911

BX Cayco 1 (2014) Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

G

666.241

BX Cayco 2 (2014) Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

G

1.670

Total classe G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

667.911

BX Cayco 1 (2014) Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

H

666.241

BX Cayco 2 (2014) Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

H

1.670

Total classe H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

667.911

BX Cayco 1 (2014) Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I

666.241

BX Cayco 2 (2014) Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I

1.670

Total classe I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

667.911

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.679.110

Modification de l’article 8.1. des statuts de la Société afin qu'il ait la teneur suivante:

« Art. 8.1. Le capital social émis de la Société est fixé à un million d’euros (1.000.000 EUR), divisé en:
- dix millions (10.000.000) de Parts Sociales Ordinaires,
- dix millions (10.000.000) de Parts Sociales de Classe A,
- dix millions (10.000.000) de Parts Sociales de Classe B,
- dix millions (10.000.000) de Parts Sociales de Classe C,
- dix millions (10.000.000) de Parts Sociales de Classe D,
- dix millions (10.000.000) de Parts Sociales de Classe E,
- dix millions (10.000.000) de Parts Sociales de Classe F,
- dix millions (10.000.000) de Parts Sociales de Classe G,
- dix millions (10.000.000) de Parts Sociales de Classe H, et
- dix millions (10.000.000) de Parts Sociales de Classe I,
chaque Part Sociale ayant une valeur nominale d’un centime d’euro (0,01 EUR) ainsi que les droits et obligations tels

qu'énoncés dans les présents Statuts.».

Après délibération, l’assemblée a décidé à l’unanimité ce qui suit:

<i>Résolution unique

L’assemblée a décidé à l’unanimité d’augmenter le capital social émis de la Société d’un montant de soixante-six mille

sept cent quatre-vingt-onze euros et dix centimes (66.791,10 EUR) afin de le porter de son montant actuel de neuf cent
trente-trois mille deux cent huit euros et quatre-vingt-dix centimes (933.208,90 EUR) à un million d’euros (1.000.000
EUR) par l’émission d’un total de six millions six cent soixante-dix-neuf mille cent dix (6.679.110) parts sociales parmi les
classes indiquées dans l’ordre du jour d’une valeur nominale d’un centime d’euro (0,01 EUR) chacune (les «Nouvelles
Parts Sociales»).

Les Souscripteurs, chacun représenté par Me Alexandre Pel, précité, ont souscrit aux Nouvelles Parts Sociales ainsi

émises dans les proportions indiquées dans l’ordre du jour suivant l’exercice de warrants émis par la Société.

La preuve du paiement du prix d’émission a été montrée au notaire.
Suite à la résolution ci-dessus, l’assemblée a décidé à l’unanimité de modifier l’article 8.1. des statuts de la Société tel

qu'énoncé dans l’ordre du jour.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, l’assemblée a été clôturée.

<i>Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incomberont à la Société en raison

du présent acte sont estimés à deux mille Euros (2.000.-EUR).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare par les présentes qu'à la demande de la partie comparante,

le présent procès-verbal est rédigé en anglais, suivi d’une traduction en langue française; à la demande de la même personne
comparante, en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

151484

L

U X E M B O U R G

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Après lecture du présent procès-verbal, le mandataire et le notaire ont signé le présent acte.
Signé: A. PEL, N. FILALI et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 14 août 2014. Relation: LAC/2014/38519. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 16 septembre 2014.

Référence de publication: 2014145218/207.
(140164620) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2014.

Atalaya Luxco PIKco, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1748 Findel, 4, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 186.929.

In the year two thousand and fourteen, on the second day of September,
Before Maître Francis Kesseler, notary, residing in Esch-sur-Alzette (Grand Duchy of Luxembourg),

was held

the extraordinary general meeting (the “Meeting”) of the shareholders of Atalaya Luxco PIKco, a société en com-

mandite par actions incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered
office at 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade
and companies' register with number B 186.929 (the “Company”), incorporated pursuant to a deed of Maître Henri
Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 17 April 2014, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations number 1843 on 15 July 2014. The articles of incorporation of the Company were
last amended pursuant to a deed of Maître Françis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Lu-
xembourg on 6 May 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1904 on 22 July
2014.

The Meeting is chaired by Mrs Fanny Kindler, lawyer, with professional address in Luxembourg (the “Chairman”).
The Chairman appoints Ms Dominique Reichelt, Rechtsanwältin, with professional address in Luxembourg, as secretary

of the Meeting (the “Secretary”).

The Meeting elects Ms Dominique Reichelt, Rechtsanwältin, with professional address in Luxembourg, as scrutineer

of the Meeting (the “Scrutineer”).

(The Chairman, the Secretary and the Scrutineer are collectively referred to as the “Board of the Meeting”).
All the shareholders are present or represented at the Meeting and the number of shares they hold are indicated on

an attendance list which will remain attached to the present deed after having been signed by the appearing parties and
the notary.

The proxies of the shareholders represented at the present Meeting will also remain attached to the present deed

and signed by all the parties.

The Board of the Meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to record that:
I.  100%  of  the  share  capital  of  the  Company,  is  duly  represented  at  this  Meeting  which  is  consequently  regularly

constituted and may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter reproduced;

II. The agenda of the Meeting is as follows:
1. Decision to reduce the nominal value of the shares from one cent (EUR 0.01) to a hundredth of a cent (EUR 0.0001);
2. Amendment of paragraph 1 of article 7 of the articles of association of the Company as follows:

“ Art. 7. The Company's share capital is set at thirty-one thousand and one euro (EUR 31,001) represented by three

hundred and ten million and ten thousand (310,010,000) shares consisting of three hundred and ten million (310,000,000)
ordinary shares (the “Ordinary Shares”) having a par value of a hundredth of a euro cent (EUR 0.0001) each and ten
thousand (10,000) management shares (the “Management Shares”) having a par value of a hundredth of a euro cent (EUR
0.0001) each.”

III. The shareholders of the Company present or represented have perfect knowledge of the agenda of the Meeting

which has been communicated to them previously.

The Meeting, after deliberation, unanimously passed the following resolutions:

<i>First Resolution

The Meeting resolves to reduce the nominal value of each share of the Company from one cent (EUR 0.01) to a

hundredth of a cent (EUR 0.0001).

151485

L

U X E M B O U R G

<i>Second Resolution

The Meeting resolves to amend paragraph 1 of article 7 of the articles of association of the Company as follows:

“ Art. 7. The Company's share capital is set at thirty-one thousand and one euro (EUR 31,001) represented by three

hundred and ten million and ten thousand (310,010,000) shares consisting of three hundred and ten million (310,000,000)
ordinary shares (the “Ordinary Shares”) having a par value of a hundredth of a euro cent (EUR 0.0001) each and ten
thousand (10,000) management shares (the “Management Shares”) having a par value of a hundredth of a euro cent (EUR
0.0001) each."

Whereof, this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, this deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing party and in
case of divergence between the English and the French text, the English version shall prevail.

This document having been read to the persons appearing, known to the notary by last name, first name, civil status

and residence, the said persons appearing signed together with the notary this deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède

L'an deux mille quatorze, le deux septembre,
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-duché de Luxembourg,

s'est tenue

l'assemblée générale extraordinaire («l'Assemblée») des actionnaires de Atalaya Luxco PIKco, une société en com-

mandite par actions constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 4, rue
Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 186.929 (la «Société»), constituée en date du 17 avril 2014 suivant acte reçu par Maître
Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1843
le 15 juillet 2014. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois en date du 6 mai 2014 suivant acte reçu
par Maître Françis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations n°1904 le 22 juillet 2014.

L'Assemblée est présidée par Madame Fanny Kindler, avocate, résidant professionnellement à Luxembourg (le «Pré-

sident»).

L'Assemblée désigne Madame Dominique Reichelt, Rechtsanwältin, résidant professionnellement à Luxembourg en

tant que secrétaire de l'Assemblée.

L'Assemblée nomme Madame Dominique Reichelt, Rechtsanwältin, résidant professionnellement à Luxembourg en

tant que scrutateur.

(Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur sont collectivement dénommés le «Conseil de l'Assemblée».) Tous les

actionnaires sont présents ou représentés à l'Assemblée et le nombre d'actions qu'ils détiennent est indiqué sur une liste
de présence qui sera annexée au présent acte après avoir été signée par les comparantes et le notaire.

Les procurations des actionnaires représentés à la présente Assemblée resteront également annexées au présent acte

et seront signées par toutes les parties.

Le Conseil de l'Assemblée ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter que:
I. 100% du capital social de la Société est dûment représenté à cette Assemblée qui est ainsi régulièrement constituée

et peut délibérer valablement sur l'ordre du jour reproduit ci-dessous;

II. Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1. Décision de réduire la valeur nominale des actions à un centième de cent d'euro (EUR 0.0001);
2. Modification du paragraphe 1 de l'article 7 des statuts de la Société comme suit:

« Art. 7. La Société a un capital souscrit de trente et un mille et un euros (EUR 31.001) représenté par trois cent dix

millions dix mille (310.010.000) actions, composées de trois cent dix millions (310.000.000) actions ordinaires (les «Ac-
tions Ordinaires») d'une valeur nominale d'un centième de cent d'euro (EUR 0,0001) chacune et par dix mille (10.000)
actions de commandité (les «Actions de Commandité») d'une valeur nominale d'un centième de cent d'euro (EUR 0,0001)
chacune.»

III. Les actionnaires de la Société présents ou représentés déclarent avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour

de l'Assemblée qui leur a été communiqué au préalable.

L'Assemblée décide unanimement, après délibération, de prendre les résolutions suivantes:

<i>Première Résolution

L'Assemblée décide de réduire la valeur nominale des actions de la Société à un centième de cent d'euro (EUR 0.0001).

<i>Seconde Résolution

L'Assemblée décide de modifier le paragraphe 1 de l'article 7 des statuts de la Société comme suit:

151486

L

U X E M B O U R G

« Art. 7. La Société a un capital souscrit de trente et un mille et un euros (EUR 31.001) représenté par trois cent dix

millions dix mille (310.010.000) actions, composées de trois cent dix millions (310.000.000) actions ordinaires (les «Ac-
tions Ordinaires») d'une valeur nominale d'un centième de cent d'euro (EUR 0,0001) chacune et par dix mille (10.000)
actions de commandité (les «Actions de Commandité») d'une valeur nominale d'un centième de cent d'euro (EUR 0,0001)
chacune.»

Dont acte, passé à Luxembourg le jours, mois et l'année figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate que sur demande de la comparante indiquée aux pré-

sentes, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même comparante
et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais prévaut Après lecture faite et inter-
prétation  donnée  aux  comparants,  connus  du  notaire  instrumentaire  par  leurs  nom,  prénom,  état  et  demeure,  les
comparants ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Kindler, Reichelt, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette, Actes Civils le 4 septembre 2014. Relation: EAC/2014/11844. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): A. Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2014143866/116.
(140163597) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2014.

Ascot Luxembourg Holdings 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 186.832.

In the year two thousand and fourteen, on the fourth day of July.
Before us Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Ascot Luxembourg Holdings 1 S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of

Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B186831,

duly represented by Maître Stéphane Joly-Meunier, having his professional address in Luxembourg, Grand Duchy of

Luxembourg, by virtue of a proxy given, which proxy, after having been signed “ne varietur” by the proxy-holder and the
undersigned notary, shall remain attached to this deed in order to be registered therewith.

Such appearing party is the sole shareholder (the “Sole Shareholder”) of Ascot Luxembourg Holdings 2 S.à r.l., a société

à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered
office at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register under number B 186832, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary
dated 29 April 2014, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (hereafter the "Company").

The appearing party, representing the entire share capital, requested the undersigned notary to act that the agenda of

the meeting is as follows:

<i>Agenda

1. Decision to restate article 5.2 of the Company’s articles of association.
The appearing party, representing the entire share capital, took the following resolution:

<i>Sole resolution:

The Sole Shareholder resolves to fully restate article 5.2 of the Company’s articles of association which shall henceforth

read as follows:

5.2. “Under the terms and conditions provided by law, the Company’s share capital may be increased or reduced by

a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles
of association. The shares may be stapled to any other instruments or debt issued by the Company by virtue of a stapling
agreement entered into between the shareholders of the Company from time to time. Any transfer of shares or instru-
ments or debt in breach of such stapling agreement shall be considered as null and void.”

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person,  the  present  deed  is  worded  in  English,  followed  by  a  German  translation.  On  express  request  of  the  same
appearing person, and in case any divergences would arise between the German and the English text, the English text will
prevail.

151487

L

U X E M B O U R G

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by surname, name and residence, said

person signed together with Us, the notary, the present original deed.

Es Folgt die Deutsche Übersetzung des Englischen Textes:

Im Jahre zweitausendundvierzehn, am vierten Juli.

Vor dem unterzeichnenden Maître Henri Hellinckx, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

Ascot Luxembourg Holdings 1 S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet und existierend nach

dem Recht des Großherzogtums Luxembourg, mit eingetragenem Gesellschaftssitz in 15, rue Edward Steichen, L-2540
Luxembourg, Großherzogtum Luxembourg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der
Nummer B 186831,

vertreten durch Maître Stéphane Joly-Meunier, wohnhaft in Luxembourg, Großherzogtum Luxembourg, aufgrund einer

ihm erteilten Vollmacht, welche nach Paraphierung „ne varietur“ durch den Notar und den Bevollmächtigten vorliegender
Urkunde als Anlage beigefügt, um dieser Urkunde einregistriert zu werden.

Die erschienene Partei ist Einzelgesellschafterin (die „Einzelgesellschafterin“) der Ascot Luxembourg Holdings 2 S.à

r.l., einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) nach Luxemburger Recht, eingetragen
in das Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 186832, mit Gesellschaftssitz in 15, rue
Edward Steichen, L- 2540 Luxemburg, wirksam gegründet am 29. April 2014 gemäß notarieller Urkunde von Herrn Maître
Henri Hellinckx, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, noch nicht veröffentlicht im Mémorial C, Receuil des Sociétés et
Associations (nachfolgend die „Gesellschaft“).

Die erschienene Partei, die das gesamte Stammkapital der Gesellschaft vertritt, ersuchte den Notar die folgenden

Beschlüsse zu beurkunden:

<i>Agenda

1. Entscheidung über Neuformulierung des Artikels 5.2. der Satzung der Gesellschaft.

Die erschienene Partei, die das gesamte Stammkapital der Gesellschaft vertritt, fasste den folgenden Beschluss:

<i>Einziger Beschluss:

Die Einzelgesellschafterin beschließt Artikel 5.2. der Satzung der Gesellschaft, wie folgt, neu zu formulieren:

5.2. „Erhöhungen- oder Herabsetzungen des Gesellschaftskapitals können im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen

erfolgen, umgesetzt durch einen Beschluss der Gesellschafter, welcher in der Weise gefasst wird, wie es für eine Änderung
dieses Gesellschaftsvertrags erforderlich ist. Die Anteile können von der Gesellschaft zu anderen Instrumenten verbunden
oder als Schuldtitel ausgegeben werden aufgrund eines Verbindungsvertrages („Stapling Agreement“) zwischen den Ge-
sellschaftern. Jede Übertragung der Anteile oder Instrumente oder Schulden im Widerspruch zu solch einem Verbin-
dungsvertrag sind nichtig und ohne jede rechtliche Wirkung.“

Der unterzeichnende Notar beherrscht die englische Sprache in Wort und Schrift und bestätigt auf Nachfrage der

erschienen Partei, dass die vorliegende Urkunde auf Englisch abgefasst ist nebst einer deutschen Fassung. Auf Wunsch
der erschienen Partei und im Falle von Unterschieden zwischen der englischen und der deutschen Fassung, soll die eng-
lische Fassung maßgeblich sein.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Tage wie zu Anfang der Urkunde erwähnt wird.

Die Urkunde wurde dem Bevollmächtigten der erschienen Partei vorgelesen, dem Notar mit Nachnamen, Vornamen,

Zivilstand  und  Wohnsitz  bekannt,  ferner  haben  der  Bevollmächtigte  und  der  Notar  die  vorliegende  Urkunde  unter-
schrieben.

Gezeichnet: S. JOLY-MEUNIER und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 14 juillet 2014. Relation: LAC/2014/32889. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - der Gesellschaft auf Begehr erteilt.

Luxemburg, den 16. September 2014.

Référence de publication: 2014144579/85.

(140164462) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2014.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

151488


Document Outline

2Win S.A.

Application Security Consultants S.à r.l.

Arend &amp; Hansen S.C.I.

Arend &amp; Partners S.C.I.

Ascot Luxembourg Holdings 2 S.à r.l.

Atalaya Luxco PIKco

bpfBOUW UK Investments S.à r.l.

Chez les Bons Amis S.à r.l.

Colonnade Holdco N° 10 S.A.

Colonnade Holdco N° 9 S.A.

Colux Real Estate S.à r.l.

Darecko S.A.

Déco-Peint Luxembourg S.à r.l.

Director S.à r.l.

eDreams ODIGEO

Emerging Markets Online Food Delivery Holding S.à r.l.

Eurobank Holding (Luxembourg) S.A.

Euroexp S.à r.l.

Flying Bird S.A.

Gasfin Development S.A.

iBO Solutions S.A.

Incoden S.A.

LSREF3 GTC Holdings S.à r.l.

Lux-O-Trend Distribution S.à r.l.

MDT Luxembourg

Parker Hannifin Partnership S.C.S.

PATRIZIA Real Estate 10 S.à r.l.

PATRIZIA Real Estate 20 S.à r.l.

PHM Investment Holdings (EUR) S.à r.l.

PHM Topco 24 Holdings S.à r.l.

Power Group Investments S.à r.l.

Ribambelle Groupe

Rousegaertchen S.A.

Rovi Global Services S.àr.l.

SaarLux Solutions S. à r. l.

Smart Advisory

Sofapi-Lux S.A.

Southerncross Holdings S.à r.l.

Tramuntana Management S.à r.l.

Transfert S.à r.l.

Trends Export S.A.

Trilux-Stahl, GmbH

W2007 Parallel Bora S.à r.l.

W2007 Parallel Lancaster S.à r.l.

Westenwind S.à r.l. &amp; Cie S.C.A.

Westenwind S.à r.l. &amp; Cie S.C.A., SICAR

Willis Lux Holdings 2 S.à r.l.

WOF II Holding S.à r.l.

WOF III Holding S.à r.l.

Zaza S.à r.l.