This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 3121
27 octobre 2014
SOMMAIRE
Augentius Luxembourg HoldCo S.A. . . . .
149782
Augentius Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . .
149782
Borotra S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
149770
Brightpoint (Luxembourg) Sàrl . . . . . . . . . .
149769
Brookridge 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
149771
CGE Investments (No. 1) S.à r.l. . . . . . . . . .
149768
City Living Group S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
149770
CORNÈR BANQUE (Luxembourg) S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
149770
Deutsche Zinshaus Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . .
149771
Dutch Venture Initiative S.A. SICAR . . . . .
149771
Fell-Systemhaus-Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
149770
Hasten Property Holdings S.à r.l. . . . . . . . .
149771
Infodatainvest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
149762
Intermeat Services S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
149762
INVESCO Real Estate Management S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
149775
Investissement International Immobilier
SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
149763
JAN.CO S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
149763
K13 Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
149763
La Coccinella S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
149763
Letzebuerger Theater a.s.b.l. . . . . . . . . . . . .
149762
Limoreal S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
149769
Lindab S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
149808
Luxdynamic S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
149768
Lux Snacks S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
149769
Metaform S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
149768
Meubles Kandel s.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
149768
NII International Holdings S.à r.l. . . . . . . . .
149769
NNS Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
149762
Partners Group European Mezzanine 2008
S.C.A., SICAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
149762
Rowan Finanz S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
149772
Salon La Brosse S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
149764
Sama-International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
149765
Schop Investissements S.A. . . . . . . . . . . . . .
149766
Simres Real Estate Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . .
149766
SJ Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
149764
Smith & Nephew International S.A. . . . . .
149767
Sofibru S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
149765
Stahr Pierre S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
149765
Telenet International Finance S.à r.l. . . . .
149764
Tiger Tail Investments S.A. . . . . . . . . . . . . .
149766
Tramet s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
149767
Treveria Seventeen S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
149808
Triton Debt Opportunities S.C.A. . . . . . . .
149766
T.Rowe Price Funds Series II Sicav . . . . . .
149765
T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
149767
Van Egmond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
149763
VEREF I Invest Co 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
149784
Violet Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
149764
Watera International . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
149767
Zencap Global S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
149787
149761
L
U X E M B O U R G
Infodatainvest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8287 Kehlen, 22, Zone Industrielle.
R.C.S. Luxembourg B 81.534.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Windhof, le 19/09/2014.
Référence de publication: 2014146181/10.
(140166525) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2014.
Intermeat Services S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.250,00.
Siège social: L-3490 Dudelange, 2, rue Jean Jaurès.
R.C.S. Luxembourg B 34.199.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
INTERMEAT SERVICES SA
Référence de publication: 2014146183/10.
(140166272) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2014.
NNS Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 133.863.
<i>Rectificatif L120041495 déposé le 14/03/2012i>
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 septembre 2014
Référence de publication: 2014145001/11.
(140165332) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2014.
Partners Group European Mezzanine 2008 S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous la
forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 2, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 131.435.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 septembre 2014.
Référence de publication: 2014145022/11.
(140165025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2014.
Letzebuerger Theater a.s.b.l., Association sans but lucratif.
Siège social: L-5711 Aspelt, 36, Um Flouer.
R.C.S. Luxembourg F 5.188.
(Mémorial C no 32 de 1949, derniers statuts modifiés déposés au Mémorial C no 2543 de 2012)
STATUTS
(modifiés et approuvés par l’Assemblée Générale du 11 septembre 2014)
Art. 2. Son siège est au 36, Um Flouer, L-5711 Aspelt.
Aspelt, le 11 septembre 2014.
Référence de publication: 2014146217/12.
(140166093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2014.
149762
L
U X E M B O U R G
Investissement International Immobilier SA, Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 28.317.
Conformément à l'article 5 de la convention de domiciliation concernant INVESTISSEMENT INTERNATIONAL IM-
MOBILIER, société anonyme, R.C.S. Luxembourg B 28317, dont le siège est déclaré à L-2212 Luxembourg, 6, place de
Nancy, nous vous déclarons mettre fin au contrat de domiciliation avec effet immédiat.
Luxembourg, le 17 septembre 2014.
Ronald Weber / Serge Stojanovic.
Référence de publication: 2014146185/10.
(140166464) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2014.
JAN.CO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 150.883.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour le Conseil d’administrationi>
Référence de publication: 2014146193/10.
(140166670) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2014.
K13 Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 79.168.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour K13 Holding S.A.
i>United International Management S.A.
Référence de publication: 2014146210/11.
(140166443) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2014.
La Coccinella S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8310 Capellen, 35, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 178.838.
Nous certifions par la présente qu'une cession de 100 parts a été effectuée le 10 septembre 2014 entre Monsieur
Alberto LEOCI, Né le 30 novembre 1963 à Monopoli, demeurant 3, rue Antoine Diederich L-4254 Esch-sur-Alzette et
Piero NICOLETTI, Né à Vallo Della Lucania (Italie) demeurant au 1a; Rue Basse L-8313 CAPELLEN.
Fait à Capellen, le 19 septembre 2014.
Référence de publication: 2014146212/11.
(140166757) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2014.
Van Egmond, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1541 Luxembourg, 70, boulevard de la Fraternité.
R.C.S. Luxembourg B 177.842.
Les comptes annuels du 06/06/2013 au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2014147038/12.
(140167511) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2014.
149763
L
U X E M B O U R G
Salon La Brosse S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4247 Esch-sur-Alzette, route de Mondercange.
R.C.S. Luxembourg B 42.736.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 22/09/2014.
Signature.
Référence de publication: 2014146968/10.
(140167113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2014.
SJ Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1251 Luxembourg, 20, avenue du Bois.
R.C.S. Luxembourg B 132.980.
Le bilan et l'annexe légale de l'exercice au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014146979/10.
(140167356) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2014.
Violet Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 162.649.
Veuillez noter que l'adresse professionnelle de M. Frank PLETSCH et de M. Jean-Christophe DAUPHIN, gérants se
situe désormais au 6, rue Eugène Ruppert, L-2435 Luxembourg.
Luxembourg, le 22 septembre 2014.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour Violet Investments S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.
Référence de publication: 2014147048/13.
(140167246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2014.
Telenet International Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 395.031.000,00.
Siège social: L-2370 Howald, 2, rue Peternelchen.
R.C.S. Luxembourg B 155.066.
<i>Extrait des résolutions écrites de l'associé unique datées du 19 septembre 2014i>
L'assemblée a décidé de renouveler le mandat de gérant de catégorie B de Michael Robert Lee avec effet au 15 juillet
2014 jusqu'au 30 septembre 2014 et le mandat de gérant de catégorie B de Michal Kristufek avec effet au 15 juillet 2014
jusqu'au 31 décembre 2014.
En conséquence des renouvellements ci-dessus, le conseil de gérance de la Société se compose de la manière suivante:
- Michael Robert Lee, gérant de catégorie B;
- Michal Kristufek, gérant de catégorie B;
- Patrick Frawley, gérant de catégorie B;
- Birgit Conix, gérant de catégorie A; et
- Luc Machtelinckx, gérant de catégorie A;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Telenet International Finance S.à r.l.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2014147001/21.
(140167451) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2014.
149764
L
U X E M B O U R G
Sama-International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8010 Strassen, 204, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 103.988.
Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014146969/9.
(140167532) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2014.
Sofibru S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 29.462.
Le Bilan au 31.12.2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014146982/10.
(140167075) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2014.
Stahr Pierre S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4981 Reckange-sur-Mess, 10, rue des Champs.
R.C.S. Luxembourg B 122.406.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014146991/10.
(140167502) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2014.
T.Rowe Price Funds Series II Sicav, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement
Spécialisé.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6C, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 180.915.
<i>Extrait des Décisions prises lors du Conseil d'Administration du 16 septembre 2014i>
Composition du Conseil d'Administration:
- Le Conseil d'Administration a noté la démission de Monsieur Edward C. Bernard en tant qu'Administrateur de la
Société avec effet au 1
er
Septembre 2014.
Au 16 septembre 2014, le Conseil d'Administration se compose comme suit:
- Mr. Peter Preisler
- Mr. Christopher Alderson
- Mr. Ian Hoddy
- Mr. Timothy Noel
- Mr. Christopher Rothery
- Mr. Robert Higginbotham
- Mr. Justin Gerbereux
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 septembre 2014.
T. ROWE PRICE FUNDS SERIES II SICAV
Au nom et pour le compte de J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
<i>Agent domiciliatairei>
Référence de publication: 2014146998/25.
(140167523) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2014.
149765
L
U X E M B O U R G
Schop Investissements S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 43.684.
Les comptes annuels au 30 avril 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014146972/9.
(140166828) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2014.
Simres Real Estate Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 24, avenue Victor Hugo.
R.C.S. Luxembourg B 169.928.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014146977/9.
(140167125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2014.
Tiger Tail Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 140.549.
<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d'Administration en date du 18 août 2014i>
- Monsieur Emmanuel THIRY, employé privé, né le 26 septembre 1984 à Libramont-Chevigny, Belgique, demeurant
professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, est nommé Président du Conseil d'Administration pen-
dant toute la durée de son mandat d'Administrateur, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2020.
Fait à Luxembourg, le 18 août 2014.
Certifié sincère et conforme
TIGER TAIL INVESTMENTS S.A.
Signatures
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2014147024/16.
(140167058) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2014.
Triton Debt Opportunities S.C.A., Société en Commandite par Actions de Titrisation.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 2C, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 182.821.
EXTRAIT
Le conseil de gérance de l'associé commandité de la Société, Triton Debt Opportunities Holding S.à r.l, a décidé, en
date du 17 septembre 2014, de
- transférer le siège social de la Société au 2C, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, avec effet au 15 septembre
2014; et
- de nommer Deloitte Audit, une société à responsabilité limité régie par les lois de Luxembourg, avec siège social au
560, rue de Neudorf, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B67895,
en tant que réviseur d'entreprise agréé, pour une période prenant fin à la date de l'assemblée générale annuelle statuant
sur les comptes annuels pour l'année sociale se terminant au 31 mars 2014.
L'associé commandité de la Société a également transféré son siège social au 2C, rue Albert Borschette, L-1246
Luxembourg, avec effet au 15 septembre 2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Triton Debt Opportunities S.C.A.i>
Référence de publication: 2014147007/20.
(140167040) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2014.
149766
L
U X E M B O U R G
Smith & Nephew International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 67.514.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014146981/9.
(140167153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2014.
Tramet s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4918 Bascharage, 38, rue Nicolas Meyers.
R.C.S. Luxembourg B 161.318.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014147026/10.
(140166914) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2014.
Watera International, Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 153.114.
Le bilan rectificatif des comptes annuels au 31 décembre 2013 déposé antérieurement en date du 30 juillet 2014 sous
la référence L 140134684 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2014147049/12.
(140167513) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2014.
T. Rowe Price (Luxembourg) Management Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6C, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 33.422.
<i>Extrait des Décisions prises lors du Conseil d'Administration du 16 septembre 2014i>
Composition du Conseil d'Administration:
- Le Conseil d'Administration a noté la démission de Monsieur Edward C. Bernard en tant qu'Administrateur de la
Société avec effet au 1
er
Septembre 2014.
Au 16 septembre 2014, le Conseil d'Administration se compose comme suit:
- Mr. Peter Preisler
- Mr. Christopher Alderson
- Mr. Ian Hoddy
- Mr. Timothy Noel
- Mr. Christopher Rothery
- Mr. Robert Higginbotham
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 septembre 2014.
T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.à r.l.
Au nom et pour le compte de J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
<i>Agent domiciliatairei>
Référence de publication: 2014146997/23.
(140167522) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2014.
149767
L
U X E M B O U R G
Metaform S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 92.245.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014146871/10.
(140167044) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2014.
Meubles Kandel s.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4220 Esch-sur-Alzette, 17, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 20.538.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014146872/10.
(140167121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2014.
CGE Investments (No. 1) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 2.115.802,00.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 77, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 163.445.
<i>Extrait des résolutions circulaires de l'associé unique du 22 septembre 2014i>
Est nommé gérant de catégorie B à partir du 22 septembre 2014 et ce pour une durée indéterminée, Monsieur Julien
Brenier né le 27 août 1983 à Le Creusot, France, demeurant professionnellement au 77 Boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1331 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 septembre 2014.
Référence de publication: 2014147245/14.
(140168380) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2014.
Luxdynamic S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 45.333.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire tenue le 10 septembre 2014i>
Le mandat des administrateurs venant à échéance, l'assemblée décide d'élire pour la période expirant à l'assemblée
générale statuant sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2014 comme suit:
<i>Conseil d'administration:i>
MM. Federigo CANNIZZARO DI BELMONTINO, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, 7, Val Sainte
Croix, L - 1371 Luxembourg, administrateur et président
Jean-Marc DEBATY, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg, 7, Val Sainte Croix,
L-1371 Luxembourg, administrateur;
Mme Angelina SCARCELLI, employée privée, résidant professionnellement au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
LUXDYNAMIC S.A.
Société Anonyme
Signatures
Référence de publication: 2014146849/20.
(140167443) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2014.
149768
L
U X E M B O U R G
Brightpoint (Luxembourg) Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 25.001,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 139.191.
Amended Balance sheet as at December 31, 2012
Replace the previous version filed under number L140061952 on April 15, 2014
Référence de publication: 2014145978/9.
(140166640) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2014.
Limoreal S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 104.512.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour LIMOREAL S.A.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2014146237/11.
(140166601) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2014.
Lux Snacks S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3260 Bettembourg, route de Mondorf.
R.C.S. Luxembourg B 168.022.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE ROLAND KOHN S.à.r.l.
259 ROUTE D'ESCH
L-1471 LUXEMBOURG
Signature
Référence de publication: 2014146223/13.
(140166579) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2014.
NII International Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.001,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 149.229.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associée unique en date du 27 août 2014i>
1. Madame Nicola FOLEY a démissionné de son mandat de gérante de catégorie A avec effet au 29 août 2014.
2. Monsieur Davy TOUSSAINT, administrateur de sociétés, né le 28 octobre 1986 à Bastogne (Belgique), demeurant
professionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommé comme gérant de catégorie A pour une
durée indéterminée avec effet au 29 août 2014.
3. Le siège de la société a été transféré de L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte à L-2453
Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert avec effet immédiat.
Veuillez prendre note que Monsieur Hugo FROMENT, gérant de catégorie A, réside désormais professionnellement
à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
Luxembourg, le 19 septembre 2014.
Pour extrait et avis sincères et conformes
<i>Pour NII International Holdings Sarl
i>Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.
Référence de publication: 2014146302/21.
(140166250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2014.
149769
L
U X E M B O U R G
Fell-Systemhaus-Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5447 Schwebsange, 111, route du Vin.
R.C.S. Luxembourg B 124.214.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014146113/10.
(140166511) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2014.
Borotra S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 114.868.
<i>Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 05.08.2014i>
<i>Sixième résolution:i>
L'Assemblée Générale décide de transférer le siège social de la société avec effet immédiat du 11A, Boulevard Prince
Henri, L-1724 Luxembourg au 11, Avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
BOROTRA S.A.
Société Anonyme
Référence de publication: 2014145991/14.
(140166324) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2014.
CORNÈR BANQUE (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 10, rue Dicks.
R.C.S. Luxembourg B 30.880.
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 15 septembre 2014 que:
- Monsieur Nicolas Schaeffer, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12 avenue de la
Porte Neuve, a démissionné en tant qu'administrateur de la société en date du 12 août 2014.
- Le Conseil d'administration a pris acte de la démission de Monsieur Nicolas Schaeffer qui sera notifiée aux actionnaires
de la Société lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 11 mars 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 septembre 2014.
Référence de publication: 2014146036/14.
(140166191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2014.
City Living Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-8362 Grass, 4, rue de Kleinbettingen.
R.C.S. Luxembourg B 161.052.
<i>Extrait des résolutions écrites de l'associé unique de la Société datées du 17 septembre 2014i>
En conséquence des révocations de Benelux Property Services de ses fonctions de gérant de catégorie A et de Philippe
Lambert de ses fonctions de gérant de catégorie B de la Société avec effet au 17 septembre 2014, l'associé unique de la
Société prend acte que la Société n'est plus gérée par un conseil de gérance mais uniquement par Charles Douglas
McGregor, gérant de catégorie A, depuis le 17 septembre 2014.
L'associé unique de la Société a décidé de redésigner ce dernier comme «gérant unique» sans distinction de catégorie.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
City Living Group S.à r.l.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2014146003/16.
(140166076) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2014.
149770
L
U X E M B O U R G
Brookridge 1, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 22, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 170.107.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014145979/9.
(140166178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2014.
Deutsche Zinshaus Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 161.577.
Die Bilanz zum 31. Dezember 2012 und die Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember 2012 abgelaufene
Geschäftsjahr wurden beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 19. September 2014.
Deutsche Zinshaus Lux S.à r.l.
Die Domizilstelle:
Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services S.A.
Référence de publication: 2014146052/14.
(140166316) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2014.
Hasten Property Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 167.621.
<i>Résolution de l'actionnaire unique en date du 26 juillet 2014i>
Il est
RESOLU d'accepter la démission de M. Nishith Gandhi en qualité de Gérant de Hasten Property Holdings S.à r.l. avec
effet au 25 juin 2014.
RESOLU de nommer Mme Samantha Pepper, 2a rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg, en qualité de Gérante
de Hasten Property Holdings S.à r.l. avec effet au 26 juin 2014.
Luxembourg, le 19 Septembre 2014.
<i>L'actionnaire uniquei>
Référence de publication: 2014146144/15.
(140166619) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2014.
Dutch Venture Initiative S.A. SICAR, Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investissement en
Capital à Risque.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 179.637.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 16 septembre 2014i>
En date du 16 septembre 2014, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de renouveler le mandat de KPMG Luxembourg en qualité de Réviseur d'Entreprises agréé, jusqu'à la prochaine
Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2015.
Luxembourg, le 19 septembre 2014.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Dutch Venture Initiative S.A. SICAR
i>Caceis Bank Luxembourg
Référence de publication: 2014146057/16.
(140166704) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2014.
149771
L
U X E M B O U R G
Rowan Finanz S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 312.154.110,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 180.891.
In the year two thousand and fourteen, on the tenth day of Septembre.
Before Maître Francis Kesseler, notary public residing in Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Rowan US Holdings (Gibraltar) Limited, private limited liability company incorporated under the laws of Gibraltar,
having its registered office at Suite 1 Burns House, 19 Town Range, registered with the Gibraltar Companies House with
number 107369 (the “Sole Shareholder”),
hereby represented by Mrs. Sophie Henryon, employee, with professional address at 5, rue Zénon Bernard, L-4030
Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.
Such proxy having been signed “ne varietur” by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to this deed to be filed with such deed with the registration authorities.
The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record as follows:
I.- The appearing party is the sole shareholder of “Rowan Finanz S.à r.l.”, a Luxembourg private limited liability company
(“société à responsabilité limitée”), having its registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-
Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 180.891,
incorporated by a deed enacted by the undersigned notary on 10 October 2013, published in the "Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations" number 2981, dated 26 November 2013 (the “Company”). The Articles have been amended
for the last time by a deed enacted by the undersigned notary on 29 January 2014, published in the "Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations" number 50084, dated 24 April 2014.
II.- That the 300,394,110 (three hundred million three hundred ninety-four thousand one hundred ten) shares with a
nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each, representing the whole share capital of the Company, are
represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the Sole Shareholder expressly
states having been duly informed beforehand.
III.- The agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Waiving of notice right;
2. Increase of the share capital of the Company by an amount of USD 11,760,000 (eleven million seven hundred sixty
thousand United States Dollars) so as to raise it from its current amount of USD 300,394,110 (three hundred million
three hundred ninety-four thousand one hundred ten United States Dollars) to USD 312,154,110 (three hundred twelve
million one hundred fifty-four thousand one hundred ten United States Dollars) by the issue of 11,760,000 (eleven million
seven hundred sixty thousand) new shares with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each, subject to the
payment of a global share premium amounting to USD 105,840,000 (one hundred five million eight hundred forty thousand
United States Dollars) payable on the share premium account of the Company, out of which an amount of USD 1,176,000
(one million one hundred seventy six thousand United States Dollars) shall be allocated to the legal reserve, the whole
to be fully paid up through a contribution in cash;
3. Subscription and payment by Rowan US Holdings (Gibraltar) Limited of all the new shares by way of a contribution
in cash;
4. New composition of the shareholding of the Company;
5. Subsequent amendment of the first paragraph of article 8 of the articles of association of the Company; and
6. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolutions have been taken:
<i>First resolution:i>
It is resolved that the Sole Shareholder waives his right to the prior notice of the current meeting; the Sole Shareholder
acknowledges being sufficiently informed on the agenda and considers being validly convened and therefore agrees to
deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is further resolved that all the relevant documentation has been
put at the disposal of the Sole Shareholder within a sufficient period of time in order to allow it to examine carefully each
document.
<i>Second resolution:i>
It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of USD 11,760,000 (eleven million seven
hundred sixty thousand United States Dollars) so as to raise it from its current amount of USD 300,394,110 (three
149772
L
U X E M B O U R G
hundred million three hundred ninety-four thousand one hundred ten United States Dollars) to USD 312,154,110 (three
hundred twelve million one hundred fifty-four thousand one hundred ten United States Dollars) by the issue of 11,760,000
(eleven million seven hundred sixty thousand) new shares with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each,
subject to the payment of a global share premium amounting to USD 105,840,000 (one hundred five million eight hundred
forty thousand United States Dollars) (the "Share Premium") payable on the share premium account of the Company,
out of which an amount of USD 1,176,000 (one million one hundred seventy six thousand United States Dollars) shall be
allocated to the legal reserve, the whole to be fully paid up through a contribution in cash by the Sole Shareholder of a
global amount of USD 117,600,000 (one hundred seventeen million six hundred thousand United States Dollars) (the
“Contribution”).
<i>Third resolution:i>
It is resolved to accept the subscription and the payment by the Sole Shareholder of the New Shares and the payment
of the Share Premium through the Contribution.
<i>Evidence of the Contribution's existencei>
A proof of the Contribution has been given.
<i>Fourth resolution:i>
As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the shareholding of the Company is now composed
of:
- Rowan US Holdings (Gibraltar) Limited: 312,154,110 (three hundred twelve million one hundred fifty-four thousand
one hundred ten shares.
The notary acts that all the shares mentioned above, representing the whole share capital of the Company, are re-
presented so that the meeting can validly decide on the resolution to be taken below.
<i>Fifth resolution:i>
As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the Contribution having been fully carried out, it
is resolved to amend the first paragraph of article 8 of the Company's articles of association so that to read as follows:
“ Art. 8. The Company's share capital is set at USD 312,154,110 (three hundred twelve million one hundred fifty-four
thousand one hundred ten United States Dollars), represented by 312,154,110 (three hundred twelve million one hundred
fifty-four thousand one hundred ten) shares with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each.”
No other amendment is to be made to this article.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about seven thousand euro (EUR 7,000.-).
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the day named at the beginning of this
document.
The document having been read to the person appearing, it signed together with us, the notary, the present original
deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Traduction française du texte qui précède
L'an deux mille quatorze, le dixième jour de septembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire établi à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
Rowan US Holdings (Gilbraltar) Limited, une société à responsabilité limitée, constituée selon les lois de Gibraltar,
ayant son siège social sis au Suite 1 Burns House, 19 Town Range, enregistrée auprès du Gibraltar Companies House
sous le numéro 107369 (l'«Associé Unique»);
ici représentée par Mme Sophie Henryon, employée, avec adresse professionnelle sise au 5, rue Zénon Bernard, L-4030
Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
Ladite procuration ayant été paraphée «ne varietur» par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et le
notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités d'enregistrement.
La partie comparante, ainsi représentée, a requis le notaire d'acter ce qui suit:
149773
L
U X E M B O U R G
I.- La partie comparante est l'associé unique de "Rowan Finanz S.à r.l.", une société à responsabilité limitée, ayant son
siège social sis au 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 180.891, constituée par acte notarié du
notaire soussigné en date du 10 octobre 2013, publié au "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations" sous le
numéro 2981 daté du 26 novembre 2013 (la «Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois
par acte notarié du 29 janvier 2014, reçu par le notaire soussigné, publié au "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations" sous le numéro 50084, daté du 24 avril 2014.
II.- Les 300.394.110 (trois cent millions trois cent quatre-vingt-quatorze mille cent dix) parts sociales d'une valeur
nominale de 1 USD (un Dollar Américain) chacune, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont repré-
sentées de sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer sur tous les points figurant à l'ordre du jour dont l'Associé
Unique reconnaît expressément avoir été dûment informé.
III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Renonciation au droit de convocation préalable;
2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de 11.760.000 USD (onze millions sept cent soixante
mille Dollars Américains) afin de le porter de son montant actuel de 300.394.110 USD (trois cents millions trois cent
quatre-vingt-quatorze mille cent dix Dollars Américains) à 312.154.110 USD (trois cent douze millions cent cinquante-
quatre mille cent dix Dollars Américains) par l'émission de 11.760.000 (onze millions sept cent soixante mille) nouvelles
parts sociales d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar Américain) chacune, moyennant le paiement d'une prime
d'émission totale d'un montant de 105.840.000 USD (cent cinq millions huit cent quarante mille Dollars Américains)
payable sur le compte prime d'émission de la Société, dont un montant de 1.176.000 USD (un million cent soixante-seize
mille Dollars Américains) sera alloué à la réserve légale de la Société, le tout devant être libéré par un apport en numéraire;
3. Souscription et paiement par Rowan US Holdings (Gibraltar) Limited des nouvelles parts sociales par voie d'apport
en numéraire;
4. Nouvelle composition de l'actionnariat de la Société;
5. Modification du premier paragraphe de l'article 8 des statuts de la Société; et
6. Divers.
Suite à l'approbation de ce qui précède par l'Associé Unique, les résolutions suivantes ont été adoptées:
<i>Première résolution:i>
Il est décidé que l'Associé Unique renonce à son droit de convocation préalable à la présente assemblée, reconnaît
avoir été suffisamment informé de l'ordre du jour et considère avoir été valablement convoqué et en conséquence accepte
de délibérer et de voter sur tous les points portés à l'ordre du jour. Il est en outre décidé que l'ensemble de la docu-
mentation pertinente a été mise à la disposition de l'Associé Unique dans un laps de temps suffisant afin de lui permettre
un examen attentif de chaque document.
<i>Deuxième résolution:i>
Il est décidé d'augmenter le capital social de la Société, d'un montant de 11.760.000 USD (onze millions sept cent
soixante mille Dollars Américains) afin de le porter de son montant actuel de 300.394.110 USD (trois cents millions trois
cent quatre-vingt-quatorze mille cent dix Dollars Américains) à 312.154.110 USD (trois cent douze millions cent cin-
quante-quatre mille cent dix Dollars Américains) par l'émission de 11.760.000 (onze millions sept cent soixante mille)
nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar Américain) chacune (les «Nouvelles Parts Sociales»),
moyennant le paiement d'une prime d'émission totale d'un montant de 105.840.000 USD (cent cinq millions huit cent
quarante mille Dollars Américains) (la «Prime d'Emission») payable sur le compte prime d'émission de la Société, dont
un montant de 1.176.000 USD (un million cent soixante-seize mille Dollars Américains) sera alloué à la réserve légale de
la Société, le tout devant être libéré par un apport en numéraire effectué par l'Associé Unique d'un montant total de
117.600.000 USD (cent dix-sept millions six cent mille Dollars Américains) (l'"Apport").
<i>Troisième résolution:i>
Il est décidé d'accepter la souscription et le paiement par l'Associé Unique des Nouvelles Parts Sociales et de la Prime
d'Emission au moyen de l'Apport.
<i>Preuve de l'existence de l'Apporti>
Preuve de l'existence de l'Apport a été donnée.
<i>Quatrième résolution:i>
En conséquence des déclarations et résolutions précédentes, l'actionnariat de la Société est désormais composé de:
- Rowan US Holdings (Gibraltar) Limited: 312.154.110 (trois cent douze millions cent cinquante-quatre mille cent dix)
parts sociales.
149774
L
U X E M B O U R G
Le notaire atteste que toutes les parts sociales mentionnées ci-dessus, représentant l'intégralité du capital social de la
Société, sont représentées de telle sorte que l'assemblée peut valablement décider de la résolution à prendre ci-dessous.
<i>Cinquième résolution:i>
En conséquence des déclarations et résolutions précédentes, et l'Apport ayant été entièrement libéré, il est décidé de
modifier le premier paragraphe de l'article 8 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 8. Le capital social de la Société est fixé à 312.154.110 USD (trois cent douze millions cent cinquante-quatre
mille cent dix Dollars Américains) représenté par 312.154.110 (trois cent douze millions cent cinquante-quatre mille cent
dix) parts sociales d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar Américain) chacune.»
Il n'y a pas d'autres modifications à faire à cet article.
<i>Estimation des fraisi>
Les coûts, frais, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être
payés par elle en rapport avec le présent acte, ont été estimés à sept mille euros (EUR 7.000,-).
Aucun autre point n'ayant été soulevé, l'assemblée a été ajournée.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, au jour figurant en tête de ce document.
Lecture ayant été faite de ce document au mandataire de la partie comparante, elle a signé avec nous, notaire, l'original
du présent acte.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que, sur demande de la partie comparante, le présent acte
est établi en anglais suivi d'une traduction en français. Sur demande de la même partie comparante, en cas de divergences
entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.
Signé: Henryon, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette, Actes Civils le 12 septembre 2014. Relation: EAC/2014/12262. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Santioni.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2014145108/186.
(140164433) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2014.
INVESCO Real Estate Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 37A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 133.753.
In the year two thousand and fourteen, on the thirty-first day of July,
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg)
THERE APPEARED:
INVESCO International Holdings Limited, a limited liability company, incorporated under the laws of England and
Wales, having its registered office at Perpetual Park, Perpetual Drive, Henley-on-thames, RG9 1HH, United Kingdom,
and entered in the Trade and Companies Register of England and Wales, under number 01641619, being the sole sha-
reholder of Invesco Real Estate Management S.à r.l.;
here represented by Corinne PETIT, private employee, professionally residing in 74, Avenue Victor Hugo, L-1750
Luxembourg, by virtue of a proxy given on 30
th
July 2014.
The appearing party, acting in its capacity as sole shareholder of INVESCO Real Estate Management S.à r.l., has re-
quested the undersigned notary to document the following:
The appearing party is the sole shareholder of INVESCO Real Estate Management S.à r.l., a limited liability company
(société à responsabilité limiteé) incorporated under the law of Luxembourg, having its registered office at 37A, Avenue
J.F. Kennedy, L - 1855 Luxembourg, having a share capital of EUR 1,504,950, incorporated by a deed of the notary Jean-
Josef Wagner, residing in Luxembourg, on 14 November 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, number 2936 on 18 December 2007 (the 'Mémorial C'), and entered in the Register of Commerce and
Companies in Luxembourg, Section B, under number B133753 (the 'Company'). The articles of incorporation have been
amended for the last time pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, dated 19
December 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1154 on 07 May 2014.
The appearing party, represented as above mentioned, recognises that it has been fully informed of the resolutions to
be taken on the basis of the following agenda:
<i>Agendai>
1. To amend the definitions of the articles of association
149775
L
U X E M B O U R G
2. To amend article 2 of the articles of association
3. To amend article 10 of the articles of association
4. To amend article 13 of the articles of association
5. To amend article 14 of the articles of association
6. To amend article 15 of the articles of association
7. To amend article 21 of the articles of association
<i>First resolutioni>
The sole shareholder resolves to amend the definitions of the articles of association of the Company. The definitions
shall now read as follows:
<i>“Definitionsi>
The following terms shall have the meaning as set out hereafter whenever used herein with initial capital letters:
«2010 Law» means the Luxembourg law dated 17 December 2010, relating to undertakings for collective investment,
as amended from time to time,
«AIFM Law» means the Luxembourg law dated 12 July 2013 on alternative investment fund managers;
«AIF» an alternative investment fund in the meaning of article 1 paragraph 39 of the AIFM Law;
«Articles» means the present articles of incorporation;
«Business Day» means any day, other than a Saturday or Sunday, when banks in Luxembourg are open for the trans-
action of normal business;
«Euro» or «EUR» means the lawful currency of the European Union member States that have adopted the single
currency in accordance with the Treaty establishing the European Community as amended by the Treaty on European
Union and as amended by the Treaty of Amsterdam;
«Management Company Board» means in case of plurality of Managers the board of Managers of the Management
Company;
«Management Regulations» means the management regulations governing the respective UCI;
«Manager» means the manager or in case of plurality of managers, a manager appointed to the Management Company
Board in accordance with these Articles or as the case may be a member of the Management Company Board;
«Share(s)» means the shares issued by the Management Company and any share issued in exchange for those shares
or by way of conversion or reclassification, and any shares representing or deriving from those shares as a result of any
increases in or reorganization or variation of the capital of the Management Company;
«Shareholder» means a holder of Shares; and
«UCI» means undertaking for collective investment.”
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder resolves to amend article 2 of the articles of association of the Company. Article 2 of the articles
of association shall now read as follows:
“ Art. 2. The corporate purpose of the Management Company is:
- the performance of all activities listed under annex II of the 2010 Law such as the management, administration, and
distribution of Luxembourg and foreign UCIs. It may notably, on behalf of the UCIs, enter into any contract, purchase,
sell, exchange and deliver any securities or other permitted assets, proceed to any registrations and transfers in its name
on behalf of the UCIs and holders of units of the UCIs, all rights and privileges, especially all voting rights attached to the
securities constituting the assets of the UCI; and
- the performance of investment management (portfolio and risk management) under annex I paragraph (1) AIFM Law.
The Management Company may in addition perform one or several other functions listed under Annex I paragraph
(2) of the AIFM Law in the course of the collective management of Luxembourg or foreign AIFs:
- administration: (i) legal and fund management accounting services, (ii) customer inquiries, (iii) valuation and pricing,
including tax returns, (iv) regulatory compliance (v) monitoring maintenance of unit/shareholder register, (vi) distribution
of income, (vii) unit/shares issues and redemptions; (viii) contract settlements, including certificate dispatch; (ix) record
keeping;
- marketing; and
- all activities linked to Luxembourg and foreign AIFs namely services necessary to meet the fiduciary duties of the
Management Company, facilities management, real estate administration activities, advice to undertakings on capital
structure, industrial strategy and related matters, advice and services relating to mergers and the purchase of undertakings
and other services connected to the management of Luxembourg or foreign AIFs and the companies and other assets in
which they have invested
149776
L
U X E M B O U R G
The Management Company may carry out any activities deemed useful for the accomplishment of its object, in ac-
cordance with chapter 15 of the 2010 Law and the AIFM Law.”
<i>Notei>
The notary drawing up the present deed has drawn the attention of the appearing party that the company, before
exercising ist new activity, has to be in possession of the corresponding approval (authorisation) in respect of the object
clause of the company, which the appearing party expressly recognized.
<i>Third resolutioni>
The sole shareholder resolves to amend article 10 of the articles of association of the Company. Article 10 of the
articles of association shall now read as follows:
“ Art. 10. In case of plurality of Managers, at the beginning of each Board meeting, the Board may decide to appoint
among its members a protempore chairman who will not benefit from a casting vote.
The Manager or in case of plurality of Managers, the Management Company Board may also choose a secretary, who
need not be a Manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Management Company
Board and of the Shareholders.
The Manager or in case of plurality of Managers, the Management Company Board, may from time to time appoint
officers of the Management Company, including a managing director, a general manager and any assistant managers or
other officers considered necessary for the operation and management of the Management Company. Officers need not
to be Managers or Shareholders of the Management Company. The officers appointed, unless otherwise stipulated herein,
shall have the powers and duties given to them by the manager or in case of plurality of managers, the Management
Company Board.
The Management Company Board shall meet upon call by any two Managers, at the place indicated in the notice of
meeting.
Written notice, containing an agenda which sets out any points of interest for the meeting, of any meeting of the
Management Company Board shall be given to all Managers at least 2 Business Days prior to the beginning of such meeting,
except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of
the meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by telegram, facsimile or e-mail transmission of each
Manager. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule
previously adopted by resolution of the Management Company Board.
Any Manager may act at any meeting of the Management Company Board by appointing, in writing or by telegram,
facsimile or e-mail transmission, another Manager as his proxy.
Any Manager who is not physically present at the location of a meeting may participate in such a meeting of the
Management Company Board by remote conference facility or similar means of communication equipment, whereby all
persons participating in the meeting can hear each other, and participating in a meeting by such means shall constitute
presence in person at such meeting.
The Management Company Board can deliberate or act validly only if at least two Managers are present or represented
at a meeting of the Management Company Board. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the Managers
present or represented.
Resolutions signed by all Managers will be as valid and effectual as if passed at a meeting duly convened and held. Such
signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letters,
telegrams, facsimile or e-mail transmissions.
The minutes of any meeting of the Management Company Board shall be signed by the chairman (if any) or, in his
absence, by any Manager.
Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by
any Manager.”
<i>Forth Resolutioni>
The sole shareholder resolves to amend article 13 of the articles of association of the Company. Article 13 of the
articles of association shall now read as follows:
“ Art. 13. The Manager or in case of plurality of Managers, the Management Company Board, may delegate its powers
to conduct the daily management and affairs of the Management Company, including the right to sign on behalf of the
Company, and its powers to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose, to officers of the Mana-
gement Company or to other persons, which at their turn may delegate their powers if they are authorised to do so by
the Manager or in case of plurality of Managers, the Management Company Board.
The Board may from time to time establish internal committees as it deems useful.”
149777
L
U X E M B O U R G
<i>Fifth Resolutioni>
The sole shareholder resolves to amend article 14 of the articles of association of the Company. Article 14 of the
articles of association shall now read as follows:
“ Art. 14. No contract or other transaction which the Management Company and any other company or firm might
enter into shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Managers or officers of the Management
Company is interested in such other company or firm by a relation, or is a director, officer or employee of such other
company or legal entity, provided that the Management Company obliges itself to never knowingly sell or lend assets of
UCIs or AIFs it manages to any of its directors or officers or any company or firm controlled by them.
In the event that any Manager or officer of the Management Company may have any personal interest in any contract
or transaction of the Management Company other than that arising out of the fact that he is a Manager, officer or employee
or holder of securities or other interests in the counter-party, such manager or officer shall, in case of plurality of
managers, make known to the Management Company Board such personal interest and shall not consider or vote upon
any such contract or transaction. Such contract or transaction, and such Manager's or officer's personal interest therein,
shall be reported to the next succeeding meeting of Shareholders.”
<i>Sixth Resolutioni>
The sole shareholder resolves to amend article 15 of the article of association of the Company. Article 15 of the
articles of association shall now read as follows:
“ Art. 15. The Management Company may indemnify any Manager or officer and his heirs, executors and administrators,
against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made
a party by reason of his being or having been a Manager or officer of the Management Company or, at its request, of any
other company of which the Management Company is a unitholder, partner, shareholder or a creditor and which he is
not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit
or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be
provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Management Company is
advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of
indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.”
<i>Seventh Resolutioni>
The sole shareholder resolves to amend article 21 of the articles of association of the Company. Article 21 of the
articles of association of the Company shall now read as follows:
“ Art. 21. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the law
of 10 August 1915, as amended from time to time, on commercial companies, and the 2002 2010 Law and the AIFM Law.”
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this
document, are estimated at approximately one thousand four hundred Euro (EUR 1,400.-).
The undersigned notary who understands English, states herewith that on request of the above appearing person the
present deed is worded in English followed by a German version, on request of the same person and in case of any
differences between the English and the German text, the English text will prevail.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by her surname, first name, civil
status and residence, the said person signed together with Us, the notary, this original deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangegangenen Texts:
Im Jahre zweitausendundvierzehn, am einunddreißigsten Juli.
Vor der unterzeichnenden Notarin Martine SCHAEFFER, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
IST ERSCHIENEN:
INVESCO International Holdings Limited, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet nach dem Recht von
England und Wales, mit Gesellschaftssitz in Perpetual Park, Perpetual Drive, Henley-on-thames, RG9 1HH, United King-
dom, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von England und Wales unter der Nummer 01641619, ist der
alleinige Gesellschafter der INVESCO Real Estate Management S.à r.l.,
vertreten durch Corinne PETIT, Privatbeamtin, mit beruflicher Adresse in 74, Avenue Victor Hugo, L-1750 Luxem-
bourg, durch Vollmacht vom 30.Juli 2014.
Die Erschienene, die im Namen des alleinigen Gesellschafters der INVESCO Real Estate Management S.à r.l. handelt,
bittet die Notarin folgendes festzuhalten:
Die erschienene Partei ist der alleinige Gesellschafter der INVESCO Real Estate Management S.à r.l., eine Gesellschaft
mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), gegründet nach luxemburgischen Recht, mit Gesellschaftssitz
149778
L
U X E M B O U R G
in 37A, Avenue J.F. Kennedy, L - 1855 Luxemburg, mit einem Gesellschaftskapital in Höhe von EUR 1.504.950 am 14
November 2007 von Herrn Notar Jean-Joseph Wagner, tätig in Sanem, gegründet, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer
2936 am 18 Dezember 2007, und eingetragen im luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer
B133753 (die ‚Gesellschaft‘). Die Satzung wurde zuletzt durch Urkunde von Notarin Martine Schaeffer, geschäftsansässig
in Luxemburg, datiert vom 19 Dezember 2013, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 1154 vom 07 Mai 2014.
Die Erschienene, vertreten wie oben erwähnt, gibt an, über die folgenden Beschlüsse der Agenda informiert zu sein:
<i>Agendai>
1. Abänderung der Definitionen der Satzung
2. Abänderung des 2. Artikels der Satzung
3. Abänderung des 10. Artikels der Satzung
4. Abänderung des 13. Artikels der Satzung
5. Abänderung des 14. Artikels der Satzung
6. Abänderung des 15. Artikels der Satzung
7. Abänderung des 21. Artikels der Satzung
<i>Erster Beschlussi>
Der alleinige Gesellschafter beschließt die Definitionen der Satzung der Gesellschaft zu ändern. Die Definitionen der
Satzung sollen wir folgt lauten:
<i>„Definitioneni>
Die folgenden Begriffe haben, wen sie mit großen Anfangsbuchstaben geschrieben sind, die ihnen jeweils zugeordnete
Bedeutung:
«Gesetz von 2010» ist das luxemburgische Gesetz vom 27 Dezember 2010 bezüglich Organismen für gemeinsame
Anlagen in seiner jeweils geltenden Fassung.
«AIFM Gesetz» ist das luxemburgische Gesetz vom 12 Juli 2013 bezüglich Manager von Alternativen Investment Fonds.
«AIF» ist ein Alternativer Investment Fond in der Bedeutung der Artikel 1 Absatz 39 des AIFM Gesetzes.
«Satzung» ist die vorliegende Satzung;
«Geschäftstag» ist ein Tag, außer Samstag und Sonntag, an dem die Banken in Luxembourg für die üblichen Geschäfte
geöffnet sind.
«Euro» oder «EUR» ist die gesetzliche Währung derjenigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die gemäß dem
Vertrag über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft, geändert durch den Vertrag über die Europäische Union und
den Vertrag von Amsterdam, die gemeinsame Währung eingeführt haben.
«Rat der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft» ist, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, der Rat der
Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft.
«Geschäftsführer» ist der Geschäftsführer, oder sofern mehrere bestellt sind, einer der gemäß dieser Satzung zum
Mitglied des Rates der Geschäftsführung bestellten Geschäftsführer bzw. ein Mitglied des Rates der Geschäftsführung.
«Gesellschaftsanteil(e)» sind die von der Verwaltungsgesellschaft ausgegebenen Anteile sowie im Tausch gegen solche
Anteile oder aufgrund einer Umwandlung oder Reklassifizierung ausgegebene Anteile sowie Anteile, die aufgrund von
Kapitalerhöhungen, Umwandlungen oder Reklassifizierung für diese Anteile stehen oder aus ihnen hervorgehen.
«Gesellschafter» ist ein Inhaber von Anteilen
«OGA» ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen.„
<i>Zweiter Beschlussi>
Der alleinige Gesellschafter beschließt den 2. Artikel der Satzung der Gesellschaft zu ändern. Der 2. Artikel der Satzung
soll wie folgt lauten:
Art. 2. Der Zweck der Verwaltungsgesellschaft ist:
- die Durchführung aller Aktivitäten, die unter Annex II des Gesetz von 2010 aufgeführt sind, wie etwa Geschäftsfüh-
rung, Verwaltung und Vermarktung von luxemburgischen und ausländischen OGAs. Insbesondere kann sie im Namen der
OGAs Verträge schließen, Wertpapiere oder andere zulässige Vermögenswerte erwerben, veräußern, tauschen und
übergeben, kann im Namen der OGAs und Anteilinhabern von OGAs Eintragungen und Übertragungen vernehmen lassen
und deren Rechte und Vorrechte ausüben, wie insbesondere die Ausübung von mit den Wertpapieren, die die Vermö-
genswerte der OGAs bilden, verbundenen Stimmrechten und.
- die Durchführung des Investment Managements (Portfoliomanagement und Risikomanagement) gemäß Annex I Ab-
satz 1 des AIFM Gesetzes Die Verwaltungsgesellschaft kann zusätzlich eine oder mehrere andere unter Annex I Absatz
2 des AIFM Gesetzes im Rahmen eines kollektiven Managements von luxemburgischen oder ausländischen OGAs ausüben:
- Verwaltung: (i) rechtliche Dienstleistungen sowie Dienstleistungen der Fondsbuchhaltung und Rechnungslegung, (ii)
Kundenanfragen, (iii) Bewertung und Preisfestsetzung, einschließlich Steuererklärungen, (iv) Überwachung der Einhaltung
149779
L
U X E M B O U R G
der Rechtsvorschriften, (v) Führung eines Anlegerregisters, (vi) Gewinnausschüttung, (vii) Ausgabe und Rücknahme von
Anteilen, (viii) Kontraktabrechnungen, einschließlich Versand der Zertifikate, (ix) Führung von Aufzeichnungen;
- Vertrieb
- Tätigkeiten im Zusammenhang mit den Vermögenswerten des luxemburgischen oder ausländischen AIF, worunter
Dienstleistungen, die zur Erfüllung der treuhänderischen Pflichten der Verwaltungsgesellschaft erforderlich sind, das Fa-
cility Management, die Immobilienverwaltung, die Beratung von Unternehmen über die Kapitalstruktur, die industrielle
Strategie und damit verbundene Fragen, Beratungs- und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Fusionen und dem Er-
werb von Unternehmen und weitere Dienstleistungen in Verbindung mit der Verwaltung des luxemburgischen oder
ausländischen AIF und der Unternehmen und anderer Vermögenswerte, in die die AIF investiert haben, fallen.
Die Verwaltungsgesellschaft kann sämtliche Tätigkeiten ausüben, die sie für die Erfüllung ihres Zwecks als nützlich
erachtet und die im Einklang mit Kapitel 15 des Gesetzes von 2010 stehen.“
<i>Anmerkungi>
Der amtierende Notar hat die Komparenten darauf aufmerksam gemacht, dass die Gesellschaft vor jeglicher neuen
Aktivität, im Besitz einer formgerechten Genehmigung in Bezug auf den Gesellschaftszweck sein muss, was die Kompa-
renten ausdrücklich anerkannt haben.
<i>Dritter Beschlussi>
Der alleinige Gesellschafter beschließt den 10. Artikel der Satzung der Gesellschaft zu ändern. Der 10. Artikel der
Satzung soll wie folgt lauten:
„ Art. 10. Im Falle von mehreren Geschäftsführern bestimmt der Rat der Geschäftsführung aus ihrer Mitte einen
Interimsvorsitzenden, dem kein entscheidendes Stimmrecht zusteht.
Der Geschäftsführer, oder, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, der Rat der Geschäftsführung der Verwal-
tungsgesellschaft, kann einen Sekretär ernennen, der kein Geschäftsführer sein muss und für die Führung des Protokolls
von Versammlungen des Rates der Geschäftsführung und von Gesellschafterversammlungen verantwortlich ist.
Der Geschäftsführer, oder, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, der Rat der Geschäftsführung der Verwal-
tungsgesellschaft, kann jeweils Bevollmächtigte («Officers») der Gesellschaft ernennen, einschließlich eines Managing
Directors, eines General Managers, eines Assistant Manager oder sonstiger Bevollmächtigte, die im Hinblick auf den
Betrieb und die Verwaltung der Verwaltungsgesellschaft für erforderlich gehalten werden. Bevollmächtigte müssen keine
Geschäftsführer, oder Gesellschafter der Verwaltungsgesellschaft sein. Die ernannten Bevollmächtigte haben die ihnen
von dem Geschäftsführer oder, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, vom Rat der Geschäftsführung der Ver-
waltungsgesellschaft zugewiesenen Befugnisse und Pflichten.
Der Rat der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft versammelt sich auf Einladung von zwei Geschäftsführern
an dem in der jeweiligen Einladung genannten Ort.
Sämtlichen Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft ist mindestens zwei Tage vor Beginn einer solchen Ver-
sammlung eine schriftliche Einladung zusammen mit einer Tagesordnung zu übermitteln, in der sämtliche Geschäftsord-
nungspunkte aufgeführt sind. Von dieser Frist kann in dringenden Ausnahmefällen abgewichen werden, in denen die
näheren Umstände in der Einladung auszuführen sind. Auf eine Einladung kann verzichtet werden, sofern sämtliche Ge-
schäftsführer einer solchen Verfahrensweise schriftlich, per Telegramm, Fax oder E-Mail zustimmen. Für einzelne
Versammlungen, deren Zeit und Ort vorab durch Gesellschafterbeschluss festgelegt worden sind, ist keine weitere Ein-
ladung erforderlich.
Geschäftsführer können sich bei Versammlungen des Rates der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft vertre-
ten lassen, indem sie einen anderen Geschäftsführer schriftlich, per Telegramm, Fax oder E-Mail zu ihrem Vertreter
ernennen.
Geschäftsführer, die an einem Versammlungsort nicht physisch anwesend sind, können an einer Versammlung des
Rates der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft per Konferenzschaltung oder auf einem ähnlichen Kommunika-
tionsweg teilnehmen, wobei sich alle Teilnehmer einer solchen Versammlung gegenseitig hören können müssen, und eine
Teilnahme an einer solchen Versammlung kommt einer persönlichen Teilnahme gleich.
Eine Versammlung der Geschäftsführer der Verwaltungsgesellschaft kann nur wirksam beraten und handeln, wenn
mindestens zwei Geschäftsführer bei einer Versammlung des Rates der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft
anwesend oder vertreten sind. Beschlüsse sind mit einfacher Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer
zu fassen.
Von sämtlichen Geschäftsführern unterzeichnete Beschlüsse sind genauso gültig und wirksam wie bei einer ordnungs-
gemäß einberufenen und abgehaltenen Versammlung gefasste Beschlüsse. Solche Unterschriften können auf einem
einzigen Dokument oder auf mehreren Ausfertigungen eines Beschlusses gezeichnet sein und können per Brief, Tele-
gramm, Fax oder E-Mail erfolgen.
Das Protokoll von Versammlungen der Geschäftsführer der Verwaltungsgesellschaft ist von dem Vorsitzenden oder
einem beliebig anderen Geschäftsführer zu unterzeichnen.
149780
L
U X E M B O U R G
Kopien von oder Auszüge aus solchen Protokollen, die gegebenenfalls in Gerichtsverfahren oder bei anderen Gele-
genheiten vorgelegt werden, sind einem beliebigen Geschäftsführer zu unterzeichnen.“
<i>Vierter Beschlussi>
Der alleinige Gesellschafter beschließt den 13. Artikel der Satzung der Gesellschaft zu ändern. Der 13. Artikel der
Satzung soll wie folgt lauten:
„ Art. 13. Der Geschäftsführer, oder, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, der Rat der Geschäftsführung der
Verwaltungsgesellschaft, kann seine Befugnisse zur Führung der täglichen Geschäfte der Verwaltungsgesellschaft, ein-
schließlich des Rechts, für die Gesellschaft zu zeichnen, sowie seine Befugnisse, Handlungen zur Förderung der Unter-
nehmenspolitik und des Gesellschaftszwecks vorzunehmen, an Bevollmächtigte der Verwaltungsgesellschaft oder andere
Personen übertragen, die wiederum berechtigt sind, Untervollmachten zu erteilen, sofern sie von dem Geschäftsführer,
oder, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, vom Rat der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft hierzu
ermächtigt worden sind.
Der Rat der Geschäftsführung kann von Zeit zu Zeit, wie es als nützlich erachtet wird, interne Komitees einsetzen.“
<i>Fünfter Beschlussi>
Der alleinige Gesellschafter beschließt den 14. Artikel der Satzung der Gesellschaft zu ändern. Der 14. Artikel der
Satzung soll wie folgt lauten:
„ Art. 14. Verträge oder andere Transaktionen der Verwaltungsgesellschaft mit einer anderen Gesellschaft oder einem
anderen Unternahmen bleiben unberührt und werden nicht unwirksam, wenn ein oder mehrere Geschäftsführer oder
Bevollmächtigte der Verwaltungsgesellschaft aufgrund persönlicher Beziehungen ein Interesse an dieser anderen Gesell-
schaft oder diesem anderen Unternehmen hat oder haben oder dort Geschäftsführer oder Bevollmächtigter oder
Mitarbeiter ist oder sind, sofern sich die Verwaltungsgesellschaft verpflichtet, nicht wissentlich Vermögenswerte von
OGAs oder AIFs, die sie verwaltet, an ihre Geschäftsführer oder Bevollmächtigte oder von diesen beherrschte Gesell-
schaften oder Unternehmen zu verkaufen oder zu verleihen.
Falls ein Geschäftsführer oder Bevollmächtigter der Verwaltungsgesellschaft möglicherweise aus anderen Gründen als
aufgrund des Umstands, das er Geschäftsführer, Bevollmächtigte, Mitarbeiter oder Inhaber von Wertpapieren oder sons-
tigen Beteiligungen des anderen Unternehmens ist, ein persönliches Interesse an einem Vertrag oder einer Transaktion
der Verwaltungsgesellschaft hat, wird der Geschäftsführer oder Bevollmächtigte, oder, sofern mehrere Geschäftsführer
bestellt sind, der Rat der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft von diesem persönlichen Interesse in Kenntnis
setzen und von einer Beteiligung an Beschlussfassungen hinsichtlich eines solchen Vertrags oder einer solchen Transaktion
absehen. Die jeweils nächste Gesellschafterversammlung ist von einem solchen Vertrag oder einer solchen Transaktion
und dem persönlichen Interesse des betreffenden Geschäftsführers oder Bevollmächtigten zu unterrichten.“
<i>Sechster Beschlussi>
Der alleinige Gesellschafter beschließt den 15. Artikel der Satzung der Gesellschaft zu ändern. Der 15. Artikel der
Satzung soll wie folgt lauten:
„ Art. 15. Die Verwaltungsgesellschaft kann einen Geschäftsführer oder, seine Erben, Testamentsvollstrecker oder
Nachlassverwalter für angemessene Kosten schadlos halten, die diesem oder diesen in Zusammenhang mit einem An-
spruch, einer Klage oder einem Verfahren entstanden sind, die möglicherweise auf der jetzigen oder früheren Tätigkeit
des Betreffenden als Geschäftsführer oder Bevollmächtigte für die Verwaltungsgesellschaft oder auf ihr Verlangen für eine
andere Gesellschaft beruhen, deren Anteilinhaber, Partner, Gesellschafter oder Gläubiger die Verwaltungsgesellschaft ist,
wenn der Betreffende insoweit keinen anderen Schadloshaltungsanspruch hat; dies gilt nicht, wenn der Geschäftsführer
oder Bevollmächtigte wegen grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz rechtskräftig verurteilt wird; wird ein Vergleich ge-
schlossen, erfolgt die Schadloshaltung nur bezüglich solcher vom Vergleich erfassten Punkte, bezüglich derer - laut
Auskunft des Rechtsberaters gegenüber der Verwaltungsgesellschaft - keine Pflichtverletzung der schadlos zu haltenden
Person vorliegt. Das vorstehende Recht auf Schadloshaltung schließt andere, dem Geschäftsführer oder Bevollmächtigte
möglicherweise zustehende Rechte nicht aus.“
<i>Siebter Beschlussi>
Der alleinige Gesellschafter beschließt den 21. Artikel der Satzung der Gesellschaft zu ändern. Der 21. Artikel der
Satzung soll wie folgt lauten:
„ Art. 21. Alle Frage, die nicht in dieser Satzung geregelt sind, sind gemäß dem Gesetz vom 10. August 1915 über die
Handelsgesellschaften in der jeweils geltenden Fassung und dem Gesetz von 2010 und dem AIFM Gesetz zu lösen.“
<i>Kosteni>
Sämtlich Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Gebühren, welche der Gesellschaft erwachsen, werden auf eintausend-
vierhundert Euro (EUR 1.400.-) geschätzt.
149781
L
U X E M B O U R G
Die unterzeichnende Notarin, die die englische Sprache spricht und versteht, erklärt hiermit, dass die vorliegende
Urkunde in englischer Sprache ausgefertigt wird, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, auf Antrag der erschienenen
Person und im Fall von Abweichungen zwischen dem englischen und deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.
Worüber die vorliegende notarielle Urkunde in Luxembourg ausgestellt wurde, an dem zu Beginn des Dokumentes
aufgeführten Tag.
Nachdem das Dokument der erschienen Person vorgelegt wurde, hat die Bevollmächtigte das vorliegende Protokoll
zusammen mit der Notarin unterzeichnet.
Signé: C. Petit et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 6 août 2014. Relation: LAC/2014/37250. Reçu soixante-quinze euros Eur
75.-.
<i>Le Receveur ff.i>
(signé): Carole FRISING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de
Commerce.
Luxembourg, le 17 septembre 2014.
Référence de publication: 2014144867/367.
(140164749) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2014.
Augentius Luxembourg HoldCo S.A., Société Anonyme,
(anc. Augentius Luxembourg S.A.).
Siège social: L-5365 Munsbach, 6, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 150.670.
In the year two thousand and fourteen, on the ninth day of September,
Before the undersigned, Maître Francis Kesseler, notary resident in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,
was held
an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of Augentius Luxembourg S.A., a société anonyme
having its registered office at 6 rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, registered with
the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 150.670 (the Company).
The Company was incorporated on 8 January 2010, pursuant to a deed drawn up by Maître Jean-Joseph WAGNER,
at that time notary resident in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations (the Mémorial) number 345 of 17 February 2010. Since that date, the Company’s articles of association
(the Articles) have been amended several times, most recently on 9 December 2011 pursuant to a deed drawn up by
Maître Edouard DELOSCH, notary resident at that time in Rambrouch, Grand Duchy of Luxembourg, published in the
Mémorial under number 336 on 8 February 2012.
The Meeting is chaired by Mrs Sophie HENRYON, private employee, residing professionally in Esch-sur-Alzette, Grand
Duchy of Luxembourg.
The chairperson appoints as secretary Mrs Claudia ROUCKERT, private employee, residing professionally in Esch-sur-
Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.
The Meeting elects as scrutineer Mrs Brigitte MARTIN, private employee, residing professionally in Esch-sur-Alzette,
Grand Duchy of Luxembourg.
The Meeting’s officers having thus been appointed, the chairperson declares and requests the notary to state:
I. That the shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an
attendance list signed by the shareholders or their authorised representatives, the Meeting’s officers and the notary. This
attendance list and the powers of attorney will be registered with this deed.
II. That it appears from the attendance list that all the shares are represented. The Meeting is thus regularly constituted
and may deliberate and decide on the items on the agenda.
III. That the agenda of the Meeting is as follows:
1. Waiver of convening notices.
2. Change of the name of the Company.
3. Restatement of article 1 of the Articles.
4. Delegation of powers.
IV. That the Meeting has unanimously taken the following resolutions:
149782
L
U X E M B O U R G
<i>First resolutioni>
The entirety of the share capital of the Company being represented at the Meeting, the shareholders waive the con-
vening notices, the shareholders represented considering themselves as duly convened and declaring having perfect
knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance.
<i>Second resolutioni>
The shareholders resolve to change the Company’s name to “Augentius Luxembourg HoldCo S.A.” and subsequently
to restate article 1 of the Articles, which shall henceforth read as follows:
“ Art. 1. Name. There exists a company in the form of a société anonyme under the name of “Augentius Luxembourg
HoldCo S.A.” (hereinafter the “Company”).”
<i>Third resolutioni>
The shareholder resolve to authorise and empower any director of the Company, each individually, with full power
of substitution to amend, on behalf of the Company, the books and registers of the Company in order to reflect the
above change.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the shareholders, this deed
is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of discrepancies, the English text prevails.
Whereof, this notarial deed is drawn up in Esch-sur-Alzette, on the date stated above.
After reading this deed aloud, the notary signs it with the Meeting’s officers and the Shareholders’ authorised repre-
sentative.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille quatorze, le neuvième jour de septembre,
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,
s’est tenue
une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) des actionnaires de Augentius Luxembourg S.A., une société
anonyme ayant son siège social au 6, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, immatri-
culée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 150.670 (la Société).
La Société a été constituée le 8 janvier 2010, suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, à l’époque notaire
de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le
Mémorial) numéro 345 du 17 février 2010. Depuis, les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés à plusieurs
reprises et le plus récemment le 9 décembre 2011, suivant acte reçu par Maître Edouard DELOSCH, à l’époque notaire
de résidence à Rambrouch, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial numéro 336 du 8 février 2012.
L’Assemblée est présidée par Madame Sophie HENRYON, employée privée, demeurant professionnellement à Esch-
sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.
Le président nomme Madame Claudia ROUCKERT, employée privée, demeurant professionnellement à Esch-sur-
Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, comme secrétaire.
L’Assemblée nomme Madame Brigitte MARTIN, employée privée, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette,
Grand-Duché de Luxembourg, comme scrutateur.
Le bureau de l’Assemblée ayant été formé, le président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:
I. Que tous les actionnaires présents ou représentés et le nombre de leurs actions sont renseignés sur une liste de
présence signée par eux ou leurs représentants, par le bureau de l’assemblée et le notaire. Ladite liste de présence ainsi
que les procurations seront enregistrées avec le présent acte.
II. Qu'il appert de la liste de présence que toutes les actions sont représentées. L’Assemblée est par conséquent
régulièrement constituée et peut délibérer et décider sur les points de l’ordre du jour.
III. Que l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
1. Renonciation aux formalités de convocation.
2. Changement de la dénomination sociale.
3. Reformulation de l’article 1 des Statuts.
4. Délégation de pouvoirs.
IV. Que l’Assemblée a pris les résolutions suivantes:
149783
L
U X E M B O U R G
<i>Première résolutioni>
L’intégralité du capital social de la Société étant représentée à l’Assemblée, l’Assemblée renonce aux formalités de
convocation, les actionnaires se considérant eux-mêmes comme ayant été dûment convoqués et déclarant avoir une
parfaite connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué à l’avance.
<i>Deuxième résolutioni>
Les actionnaires décident de modifier la dénomination de la Société en «Augentius Luxembourg HoldCo S.A.» et par
suite, de reformuler l’article 1 des Statuts qui se lit désormais comme suit:
« Art. 1
er
. Nom. Il existe une société anonyme sous la dénomination «Augentius Luxembourg HoldCo S.A.» (ci-
après la «Société»).»
<i>Troisième résolutioni>
Les actionnaires décident d’autoriser et de donner pouvoir à tout administrateur de la Société, individuellement, avec
tout pouvoir de substitution de modifier, pour le compte de la Société, les livres et registres de la Société afin de refléter
le susdit changement.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que, à la demande des actionnaires, le présent acte est
rédigé en anglais, suivi d'une version française et que, en cas de divergences, la version anglaise fait foi.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, à la date qu'en tête des présentes.
Après avoir lu le présent acte à voix haute, le notaire le signe avec le bureau de l’Assemblée et le mandataire des
actionnaires.
Signé: Henryon, Rouckert, Martin, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette, Actes Civils le 11 septembre 2014. Relation: EAC/2014/12161. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. Halsdorf.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2014144584/111.
(140164440) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2014.
VEREF I Invest Co 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 220.466,00.
Siège social: L-2730 Luxembourg, 22, rue Michel Welter.
R.C.S. Luxembourg B 155.892.
In the year two thousand and fourteen, on the fifth day of September.
Before Maître Francis KESSELER, notary residing in Esch-sur-Alzette (Grand Duchy of Luxembourg).
THERE APPEARED
The board of managers of the Company, here represented by James MURPHY with professional address in Howald,
Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal, and whose copy, after having been signed ne varietur by the
appearing party and the undersigned notary will be annexed to this document to be filed with it with the registration
authorities.
Who declared and required the notary to record that:
I) VEREF I Invest Co 1 S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company having its registered office at 22, rue
Michel Welter, L-2730 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B
155.892, was incorporated by a deed of the undersigned notary on September 29, 2010, published in the Mémorial C on
November 10, 2010, number 2420 (the “Company”). The articles of association of the Company have been amended for
the last time by a deed of the undersigned notary dated April 30, 2013, published in the Mémorial C on August 16, 2013,
number 1987.
II) According to article 6 of the articles of association of the Company, the issued capital of the Company is fixed at
two hundred nineteen thousand nine hundred seventy one Euro (EUR 219,971.-) represented by three hundred fifty eight
thousand five hundred eighty (358,580) redeemable parts of class A and two hundred four thousand five hundred seventy
(204,570) redeemable parts redeemable parts in each of classes B to J, all having a par value of ten Euro cents (EUR 0.10)
each and entirely subscribed for and fully paid up.
Furthermore, according to article 6 of the articles of association of the Company, the Company has an authorized
capital of one hundred and ninety nine million nine hundred twenty nine thousand four hundred ninety two Euro (EUR
199,929,492.-) represented by one hundred and ninety nine million six hundred forty one thousand four hundred twenty
149784
L
U X E M B O U R G
(199,641,420) redeemable parts of class A and one hundred and ninety nine million nine hundred sixty one thousand five
hundred (199,961,500) redeemable parts in each of classes B to J, all having a par value of ten Euro cents (EUR 0.10) each.
During the period of five (5) years from the date of the publication of said articles of association, the sole manager or
the board of managers are authorised to issue additional parts of different classes and to grant options to subscribe for
such parts up to the amount of the authorised capital (without taking account of the capital already issued), to such
persons and on such terms as they shall see fit (and specifically to proceed to such issue without reserving for the existing
partners a preferential right to subscribe to the parts to be issued).
Whenever the sole manager or the board of managers effect an increase of capital in whole or in part they shall be
obliged to take steps to amend article 6 in order to record the change and the sole manager or the board of managers
are authorised to take or authorise the steps required for the execution and publication of such amendment in accordance
with legal requirements.
The period or extent of such authority may be extended by the partners in general meeting from time to time, in the
manner required for amendment of the articles of association.
III) Pursuant to this authorization, the board of managers has decided on September 5, 2014:
1. to increase the capital of the Company - with effect on the date of receipt of the relevant funds by the Company’s
account bank - by an amount of four hundred ninety five Euro (EUR 495.-) so as to raise it from its present amount of
two hundred nineteen thousand nine hundred seventy one Euro (EUR 219,971.-) to two hundred twenty thousand four
hundred sixty six Euro (EUR 220,466.-) by the issuance of four thousand nine hundred fifty (4,950) new parts having a
par value of ten Euro cents (EUR.10) each (the “New Parts”) and carrying a total issue premium forty nine thousand five
hundred and five Euro (EUR 49,505.-), divided into:
- five hundred fifty (550) redeemable parts of class B;
- five hundred fifty (550) redeemable parts of class C;
- five hundred fifty (550) redeemable parts of class D;
- five hundred fifty (550) redeemable parts of class E;
- five hundred fifty (550) redeemable parts of class F;
- five hundred fifty (550) redeemable parts of class G;
- five hundred fifty (550) redeemable parts of class H;
- five hundred fifty (550) redeemable parts of class I; and
- five hundred fifty (550) redeemable parts of class J; and
2. to approve (i) the subscription by the existing sole partner of the Company, VEREF I Management S.à r.l. acting for
and on behalf of Victory European Real Estate Fund I, of all the New Parts, and (ii) the full payment thereof by means of
a contribution in cash for an aggregate value of fifty thousand (EUR 50,000.-) as will be evidenced by a certificate from
the Company’s account bank certifying that the relevant funds have been transferred to the Company. The funds having
been received by the Company’s account bank on September 5, 2014 - which was proven by production of the above-
mentioned certificate, the capital increase shall take effect as of September 5, 2014.
IV) As a consequence of such increase of capital, the first paragraph of article 6 of the articles of association of the
Company will now read as follows:
“ Art. 6. The Company's issued corporate capital is set at two hundred twenty thousand four hundred sixty six Euro
(EUR 220,466.-), consisting of the following redeemable parts of ten Euro cents (EUR.10.-) each:
- three hundred fifty eight thousand five hundred eighty (358,580) redeemable parts of class A,
- two hundred five thousand one hundred twenty (205,120) redeemable parts of class B,
- two hundred five thousand one hundred twenty (205,120) redeemable parts of class C,
- two hundred five thousand one hundred twenty (205,120) redeemable parts of class D,
- two hundred five thousand one hundred twenty (205,120) redeemable parts of class E,
- two hundred five thousand one hundred twenty (205,120) redeemable parts of class F,
- two hundred five thousand one hundred twenty (205,120) redeemable parts of class G,
- two hundred five thousand one hundred twenty (205,120) redeemable parts of class H,
- two hundred five thousand one hundred twenty (205,120) redeemable parts of class I, and
- two hundred five thousand one hundred twenty (205,120) redeemable parts of class J.
(…)”
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.
WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
149785
L
U X E M B O U R G
The document having been read to the person appearing, known to the undersigned notary by name, last name, civil
status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.
Follows the french version
L’an deux mille quatorze, le cinq septembre.
Par devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg).
A COMPARU
Le conseil de gérance de la Société, ici représenté par James MURPHY demeurant professionnellement à Howald,
Luxembourg, en vertu d’une procuration lui conférée sous seing privé dont la copie, après avoir été signée ne varietur
par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités
de l’enregistrement.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d’acter les déclarations suivantes:
I) VEREF I Invest Co 1 S.à r.l., une société à responsabilité limitée avec siège social au 22, rue Michel Welter, L-2730
Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 155.892,
a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 29 septembre 2010, publié au Mémorial C le
10 novembre 2010, numéro 2420 (la «Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant
acte du notaire instrumentant en date du 30 avril 2013, publié au Mémorial C le 16 août 2013, numéro 1987.
II) Selon l’article 6 des statuts de la Société, le capital social émis de la Société est fixé à deux cent dix-neuf mille neuf
cent soixante et onze (EUR 219.971,-) représenté par trois cent cinquante-huit mille cinq cent quatre-vingt (358,580)
parts sociales rachetables de classe A parts sociales rachetables de classe A et deux cent quatre mille cinq cent soixante-
dix (204,570) parts sociales rachetables dans chacune des classes B à J, toutes d’une valeur nominale dix centimes d'Euro
(EUR 0,10) chacune et souscrites et entièrement libérées.
De plus, selon l’article 6 des statuts de la Société, la Société a un capital autorisé de cent quatre-vingt-dix-neuf million
neuf cent vingt-neuf mille quatre cent quatre-vingt-douze Euro (EUR 199.929.492,-) représenté par cent quatre-vingt-dix-
neuf million six cent quarante et un mille quatre cent vingt (199.641.420) parts sociales rachetables de classe A et cent
quatre-vingt-dix-neuf million neuf cent soixante et un mille cinq cents (199.961.500) parts sociales rachetables dans cha-
cune des classes B à J, toutes d’une valeur nominal de dix centimes d’Euro (EUR 0,10) chacune.
Durant la période de cinq (5) ans à compter de la date de publication desdits statuts, le gérant unique ou le conseil de
gérance est autorisé par les présentes à émettre des parts sociales additionnelles et à accorder des options pour souscrire
des parts sociales additionnelles jusqu’au montant du capital autorisé (sans prendre en compte le capital déjà émis) aux
personnes et aux conditions qu’il jugera adéquates (et spécifiquement de procéder en la matière sans réserver un droit
préférentiel aux associés existants en vue de la souscription des parts sociales à émettre).
Lorsque le gérant unique ou le conseil de gérance effectue une augmentation de capital, en entier ou en partie, il sera
tenu de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 6 afin d’enregistrer le changement, et le gérant unique
ou le conseil de gérance est autorisé à prendre ou à autoriser les mesures requises en vue de l’exécution et de la publication
de tels amendements conformément aux exigences légales.
La période ou l’étendue de cette autorisation peut être prorogée ou accrue par les associés en assemblée générale
de temps en temps de la manière requise pour la modification des statuts.
III) En exécution des pouvoirs qui lui sont conférés par les stipulations susmentionnées, le conseil de gérance a décidé
le 5 septembre 2014:
1. de procéder à une augmentation de capital de la Société - prenant effet en date de réception des fonds nécessaires
par la Société - à concurrence de quatre cent quatre-vingt-quinze Euro (EUR 495.-) pour porter son montant actuel de
deux cent dix-neuf mille neuf cent soixante et onze Euro (EUR 219.971,-) à deux cent vingt mille quatre cent soixante-
six Euro (EUR 220.466.-) par l’émission de quatre mille neuf cent cinquante (4.950) parts sociales nouvelles d’une valeur
nominale de dix Euro centimes (EUR.10) chacune et ayant une prime d’émission totale de quarante-neuf mille cinq cent
cinq Euro (EUR 49.505) (les «Nouvelles Parts»), divisées entre;
- cinq cent cinquante (550) parts sociales rachetables de classe B;
- cinq cent cinquante (550) parts sociales rachetables de classe C;
- cinq cent cinquante (550) parts sociales rachetables de classe D;
- cinq cent cinquante (550) parts sociales rachetables de classe E;
- cinq cent cinquante (550) parts sociales rachetables de classe F;
- cinq cent cinquante (550) parts sociales rachetables de classe G;
- cinq cent cinquante (550) parts sociales rachetables de classe H;
- cinq cent cinquante (550) parts sociales rachetables de classe I; et
- cinq cent cinquante (550) parts sociales rachetables de classe J; et
2. d’approuver (i) la souscription par l’associé unique actuel de la Société, VEREF I Management S.à r.l., agissant pour
et au nom du fonds d’investissement Victory European Real Estate Fund I, de toutes les Nouvelles Parts, ainsi (ii) que la
149786
L
U X E M B O U R G
libération intégrale de celles-ci par un apport en espèces pour un montant total de cinquante mille Euro (EUR 50.000,-)
tel qu’il résulte du certificat bancaire prouvant la réception des fonds nécessaires par la Sociétés.
Les fonds ayant été reçus par la banque de la Société le 5 septembre 2014 - ce qui a été prouvé par production du
certificat bancaire susmentionné, l’augmentation de capital prendra effet le 5 septembre 2014.
IV) A la suite de cette augmentation de capital, le premier alinéa de l’article 6 des statuts de la Société aura désormais
la teneur suivante:
« Art. 6. Le capital social émis de la Société est fixé à deux cent vingt mille quatre cent soixante-six Euro (EUR 220.466.-),
représenté par les parts sociales rachetables suivantes d’une valeur nominale de dix centimes Euro (EUR.10) chacune:
- trois cent cinquante-huit mille cinq cent quatre-vingt (358.580) parts sociales rachetables de classe A,
- deux cent cinq mille cent vingt (205.120) parts sociales rachetables de classe B,
- deux cent cinq mille cent vingt (205.120) parts sociales rachetables de classe C,
- deux cent cinq mille cent vingt (205.120) parts sociales rachetables de classe D,
- deux cent cinq mille cent vingt (205.120) parts sociales rachetables de classe E,
- deux cent cinq mille cent vingt (205.120) parts sociales rachetables de classe F,
- deux cent cinq mille cent vingt (205.120) parts sociales rachetables de classe G,
- deux cent cinq mille cent vingt (205.120) parts sociales rachetables de classe H,
- deux cent cinq mille cent vingt (205.120) parts sociales rachetables de classe I, et
- deux cent cinq mille cent vingt (205.120) parts sociales rachetables de classe J,
(…).»
Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande du comparant, le présent
acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française. Sur la demande du même comparant et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom, état
et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Murphy, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette, Actes Civils le 9 septembre 2014. Relation: EAC/2014/12032. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M.Halsdorf.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2014144526/171.
(140164367) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2014.
Zencap Global S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 2.357.100,00.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 180.880.
In the year two thousand and fourteen, on the tenth day of July.
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
1. Global Fin Tech Holding S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce
et des Sociétés) under number B 184.665, having its registered office at 7, avenue J.P. Pescatore, L-2324 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg,
being the holder of twelve thousand four hundred ninety-nine (12,499) common shares and five thousand (5,000) series
A shares of the Company,
here represented by Ms Alix van der Wielen, maître en droit, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a
proxy, given in Berlin, Germany, 2 July 2014, and in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 1 July 2014;
2. Bambino 53. V V UG (haftungsbeschränkt), a limited liability company (Unternehmergesellschaft (haftungsbes-
chränkt)) existing under the laws of Germany registered with the commercial register at the local court of Charlottenburg,
Germany, under number HRB 126893 B, having its registered address at Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Germany,
being the holder of one (1) common share of the Company,
here represented by Ms Alix van der Wielen, maître en droit, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a
proxy, given in Berlin, Germany, on 2 July 2014;
149787
L
U X E M B O U R G
3. AI Zencap Holdings LLC, a limited liability company under the laws of the State of Delaware, United States of
America, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under registration number 5227608, with its
registered office at c/o Corporation Services Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808,
United States of America,
being the holder of three thousand six hundred twenty-five (3,625) series A shares, seven hundred eighty-six (786)
series B shares and eight hundred thirty-nine (839) series C shares of the Company,
here represented by Ms Alix van der Wielen, maître en droit, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a
proxy, given in New York, United States of America, on 30 June 2014.
4. Aismare Lux Holdings S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 176.544,
having its registered office at 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, and having a
share capital of forty-three thousand euros (EUR 43,000) (hereinafter “Aismare”), participating and voting only for pur-
poses of agenda point 3 et seqq.,
becoming the holder of eight hundred twenty-one (821) series C shares of the Company,
here represented by Ms Alix van der Wielen, maître en droit, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a
proxy, given in Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, on 1 July 2014.
The said proxies, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary will remain annexed
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The parties 1., 2. and 3. (the “Existing Shareholders”) are all the shareholders of of Zencap Global S.à r.l. (the “Com-
pany”), a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,
having its registered office at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the
Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 180.880 and incorporated pursuant to a deed of the notary
Maître Carlo Wersandt, residing in Luxembourg, on 27 September 2013, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés
et Associations number 2968 dated 25 November 2013. The articles of association were amended for the last time
pursuant to a deed of the notary Henri Hellinckx residing in Luxembourg on 14 May 2014, not yet published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
The Existing Shareholders representing the entire share capital and having waived any notice requirement, the general
meeting of shareholders is regularly constituted and may validly deliberate on the following agenda whereby Aismare
participates and votes for purpose of agenda point 3 et seqq. only:
<i>Agendai>
1. Acceptance of Aismare Lux Holdings S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number
B 176.544, having its registered office at 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, and
having a share capital of forty-three thousand euros (EUR 43,000), as new shareholder of the Company.
2. Increase of the Company’s share capital by an amount of eight hundred twenty-one euro (EUR 821) so as to raise
it from its current amount of twenty-two thousand seven hundred fifty euro (EUR 22,750) up to twenty-three thousand
five hundred seventy-one euro (EUR 23,571) by issuing eight hundred twenty-one (821) Series C Shares with a nominal
value of one euro (EUR 1) each.
3. Subsequent amendment of article five point one (5.1) of the articles of association of the Company so that it shall
henceforth read as follows:
" Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company’s share capital is set at twenty-three thousand five hundred seventy-one Euros (EUR 23,571.00),
represented by
5.1.1 twelve thousand five hundred (12,500) common shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each (he-
reinafter “Common Shares”),
5.1.2 eight thousand six hundred twenty-five (8,625) series A shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each
(hereinafter “Series A Shares”),
5.1.3 seven hundred eighty-six (786) series B shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each (hereinafter
“Series B Shares”) and
5.1.4 one thousand six hundred sixty (1,660) series C shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each
(hereinafter “Series C Shares”, the Series A Shares, the Series B Shares and the Series C Shares hereinafter also referred
to as “Preferred Shares”).
The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by these
articles of association or by the Law.”
4. Full restatement of the articles of association of the Company so that they shall henceforth read as follows:
149788
L
U X E M B O U R G
A. “Name - Purpose - Duration - Registered office
Art. 1. Name. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name Zencap Global
S.à r.l. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial
companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.
Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign
companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio.
2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it
holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the
Company.
2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by
issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.
2.4 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities
which it considers useful for the accomplishment of these purposes, in view of its realisation by sale, exchange or other-
wise.
Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
Art. 4. Registered Office.
4.1 The registered office of the Company is established in the city of Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by decision of the board of managers. It
may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by resolution of the shareholders,
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution
of the board of managers.
4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances
or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
traordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwiths-
tanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.
B. Share capital - Shares
Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company’s share capital is set at twenty-three thousand five hundred seventy-one Euros (EUR 23,571.00),
represented by
5.1.1 twelve thousand five hundred (12,500) common shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each (he-
reinafter “Common Shares”),
5.1.2 eight thousand six hundred twenty-five (8,625) series A shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each
(hereinafter “Series A Shares”),
5.1.3 seven hundred eighty-six (786) series B shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each (hereinafter
“Series B Shares”) and
5.1.4 one thousand six hundred sixty (1,660) series C shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each
(hereinafter “Series C Shares”, the Series A Shares, the Series B Shares and the Series C Shares hereinafter also referred
to as “Preferred Shares”).
The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by these
articles of association or by the Law.
5.2 The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
5.3 Each of (i) Global Fin Tech Holding S.à. r.l. (“Rocket”), (ii) AI Zencap Holdings LLC (“Access”) and Aismare Lux
Holdings S.à r.l. (“Aismare”; Rocket, Access and Aismare jointly the “Investors” and each an “Investor”) shall be entitled
to subscribe for such amount of further shares to be issued in the course of a capital increase implementing an investment
offer of a third party (being neither a shareholder nor a company affiliated to a shareholder within the meaning of sections
15 et seqq. German Stock Corporation Act (AktG) (a “Third Party Investor”)) and which has been approved by a Super
Majority (a “Third Party Investment”) - irrespective whether made by the Third Party Investor or one or more matching
149789
L
U X E M B O U R G
shareholders - required to maintain up to its percentage ownership in the Company prior to such capital increase under
the same terms and conditions on which the Third Party Investment is based on. The respective Investor shall inform the
Company by binding declaration within three (3) weeks if it intends to exercise its right pursuant to the foregoing sentence
of this Article 5.3 following which the Third Party Investment (to the extent not taken up by the Investors under this
Article 5.3) may proceed.
Art. 6. Shares.
6.1 The Company’s share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of
the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.
6.5 The Company may accept contributions without issuing shares or other securities in consideration and may allocate
such contributions to one or more distributable reserves. Decisions as to the use of any such distributable reserves are
to be taken by the shareholder(s) or the manager(s) as the case may be, subject to the Law and these articles of association.
Art. 7. Register of Shares - Transfer of Shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection
by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.
7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall
appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.
7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given
by the shareholders at a majority of three quarters of the share capital and subject to the provisions of any shareholders
agreement between the shareholders, if any, in particular, any rights of first refusal, rights of pre-emption or tag-along
rights or drag-along rights contained in any shareholders’ agreement between the shareholders. To the extent that such
approval has been granted, an additional consent to the transfer of shares is not required:
7.4.1 in any case of a transfer, assignment or any other disposal of shares by any Investor to a company affiliated to
such Investor within the meaning of sections 15 et seqq. German Stock Corporation Act (AktG);
7.4.2 in case of a sale, transfer, assignment or any other disposal of shares by any Investor to a company (x) which is
directly or indirectly Controlling, Controlled by or under common Control with (i) this Investor or (ii) by one or more
direct or indirect shareholders of the respective Investor (each a “Controlled Company”), whereas “Control” or “Con-
trolled” or “Controlling” shall mean the direct or indirect domination of the company by way of (a) managing the company
as managing shareholder, (b) holding the majority of shares or (c) holding the majority of voting rights by means of a
contractual voting pool, or (d) the unilateral ability to cause, directly or indirectly, the direction of the management and
policies of a person, whether through the ownership of voting securities or otherwise, or (y) in which the respective
Investor or one or more shareholders of such Investor has a direct or indirect majority shareholding;
7.4.3 in case of a transfer, assignment or any other disposal of shares (i) to a party acquiring shares under the simplified
employee participation or (ii) to the Company and/or any Investor pursuant to a call-option under a vesting scheme.
7.5 In the cases provided for in Article 7.4.1 through 7.4.3 above, no duties to offer for sale apply, nor do any rights
of first refusal, rights of pre-emption or tag-along rights or drag-along rights in favour of other shareholders apply.
7.6 Any transfer, assignment or any other disposal of shares shall become effective towards the Company and third
parties through the notification of the transfer, assignment or any other disposal to, or upon the acceptance of the transfer,
assignment or any other disposal by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.
7.7 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject
to the approval of such transfer given by shareholders holding at least three quarters of the share capital (a “Super
Majority”) (which, for these purposes, shall exclude the shares of the deceased shareholder). Such approval is, however,
not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse or any other legal
heir of the deceased shareholder.
Art. 8. Liquidation and Sale Preferences.
8.1 In case (i) of any sale of at least fifty per cent (50%) of all shares in the Company, or a swap or a take-over of the
Company in an economically comparable way in a single or more related transactions or in close time proximity to one
another, or (ii) of the liquidation of the Company or (iii) of any sale or transfer of shares in the Company either to third
parties or other shareholders that would result in either more than fifty per cent (50%) of the share capital or more than
fifty per cent (50%) of the voting rights being owned by the acquiring party/parties (change of control) as a result of one
or more related acquisitions, (each of the events described in (i), (ii) and (iii) is hereinafter referred to as a “Liquidity
Event”), the proceeds (“Exit Proceeds”) - subject to Article 8.2 through Article 8.4 below - will be distributed in accor-
dance with Article 8.5 to the shareholders pro rata corresponding to their participation in the Liquidity Event.
149790
L
U X E M B O U R G
8.2 On a first level (“First Level”) the holders of Series C Shares shall receive an amount which equals the amount of
their respective total investment made in the Company (consisting of the nominal amount of the Series C Shares acquired
by that holder and any share premium and/or other capital contribution (account 115) paid by that holder to the Com-
pany). If the Exit Proceeds do not suffice for the payments to be made on the First Level, the Exit Proceeds shall be
allocated to the holders of Series C Shares pro rata to the amounts that would have been allocated to the holders of
Series C Shares on the First Level if the Exit Proceeds were sufficient.
8.3 On a second level (“Second Level”) the holders of Series B Shares shall receive an amount which equals the amount
of their respective total investment made in the Company (consisting of the nominal amount of the Series B Shares
acquired by that holder and any share premium and/or other capital contribution (account 115) paid by that holder to
the Company). If the Exit Proceeds do not suffice for the payments to be made on the Second Level, the Exit Proceeds
shall be allocated to the holders of Series B Shares pro rata to the amounts that would have been allocated to the holders
of Series B Shares on the Second Level if the Exit Proceeds were sufficient.
8.4 On a third level (“Third Level”) the holders of Series A Shares shall receive an amount which equals the amount
of their respective total investment made in the Company (consisting of the nominal amount of the Series A Shares
acquired by that holder and any share premium and/or other capital contribution (account 115) paid by that holder to
the Company). If the Exit Proceeds do not suffice for the payments to be made on the Preferred Level, the Exit Proceeds
shall be allocated to the holders of Series A Shares pro rata to the amounts that would have been allocated to the holders
of Series A Shares on the Preferred Level if the Exit Proceeds were sufficient.
8.5 After the payments on the First, the Second and the Third Level have been made, the remaining Exit Proceeds
shall be allocated on a common level (“Common Level”) to all shareholders pro rata corresponding to their participation
in the Liquidity Event. Any amounts received by any shareholder on the First, the Second and the Third Level shall reduce
the amount to be allocated to such shareholder on the Common Level and shall be allocated subsequently pursuant to
this Common Level provided that no shareholder shall be obliged to repay any amount received on the First, the Second
and the Third Level. The allocation at the Common Level shall be made until all Exit Proceeds have been distributed to
the shareholders. Irrespective of whether or not the sale of shares is made in one Liquidity Event or after the Liquidity
Event in one transaction or more transactions no shareholder shall receive for the sale of all of its shares (and shall repay
any exceeding amount to the other shareholders) an amount exceeding the higher of (i) its share in the total Exit Proceeds
or proceeds pro rata to the shares sold on a common equivalent basis or (ii) the amount allocated to such shareholder
on the First, the Second and the Third Level from a subsequent sale. All rights related to the liquidity preference stipulated
herein can only be exercised once.
8.6 The preferred allocation on the First, the Second and the Third Level applies to each of the respective Preferred
Shares as long as on the respective Preferred Shares the respective amount stipulated in Article 8.2 has not yet been
distributed once.
Art. 9. Redemption of Shares.
9.1 The Company may redeem its own shares. The voting rights of any of its shares held by the Company are suspended,
for as long as they are held by the Company.
9.2 Shares of a shareholder may be redeemed without such shareholder’s consent, if:
9.2.1 insolvency proceedings are opened over the assets of the shareholder or the opening of insolvency proceedings
is rejected for lack of assets;
9.2.2 the share of a shareholder is seized or enforcement proceedings are otherwise initiated against such share and
such enforcement proceedings are not finally closed within two (2) months.
Upon receipt by such shareholder of the declaration of redemption sent by the board of managers, the shares shall
automatically be redeemed without any further action being required. The present articles together with the declaration
of redemption constitute together a valid instrument in writing for the purposes of article 190 of the Law and the Company
hereby acknowledges and accepts the transfer of the shares in such case and undertakes to register the transfer in its
share register and to proceed with the relevant filings required by law.
9.3 If the share is held by several persons, it is sufficient that the ground for redemption exists with respect to one
person; independently of this, several jointly entitled persons can only exercise the shareholders’ rights in a uniform way
through one jointly entitled person to be appointed for this purpose without undue delay after the joint entitlement
arises.
9.4 The board of managers may declare a redemption. The redemption declaration takes effect upon receipt of the
declaration by the shareholder concerned and if a respective shareholders’ resolution is adopted (except in case of Article
9.2 of these articles of association, in which no declaration by the shareholder concerned and no respective shareholders’
resolution is required).
Art. 10. Compensation for Redemption.
10.1 Redemption is made against compensation.
10.2 The compensation consists of a total amount equal to the market value of the redeemed shares. The effective
date is the date before the redemption resolution.
149791
L
U X E M B O U R G
10.3 The compensation for redemption shall be due and payable immediately upon redemption of the shares.
10.4 The withdrawing shareholder shall not be entitled to request the Company to provide security for outstanding
amounts including interest.
10.5 In the event of dispute regarding the amount of the payable compensation for redemption, such compensation is
to be determined by an auditor as expert arbitrator who shall jointly be appointed by the shareholders. If no agreement
is reached, the expert arbitrator shall be selected by the President of the Tribunal d’Arrondissement upon request of a
shareholder or of the Company. The decision of the expert arbitrator shall be binding. The costs of the expert opinion
shall be borne by the Company and the requesting shareholder in equal parts, the part allocated to such shareholder shall
be set off with the compensation for redemption and the compensation for redemption shall be reduced accordingly.
The shareholder shall bear the remaining costs in case the redemption price does not cover the costs allocated to the
shareholder for the expert opinion.
Art. 11. Request of Assignment in lieu of Redemption.
11.1 The Company may decide that, in lieu of redemption, the shareholder concerned shall transfer the shares to a
person named by the Company (including another shareholder of the Company), including also partial redemption or
partial assignment of the shares to the Company or to a person named by the Company.
11.2 This Article 11 applies with the proviso that the compensation, as provided for in Article 10 of these articles of
association, for the shares to be assigned is owed by the person acquiring the shares and that the Company shall be liable
like a guarantor.
C. Decisions of the shareholders
Art. 12. Collective Decisions of the Shareholders.
12.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these
articles of association.
12.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
12.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise
conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case,
each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his
vote in writing.
12.4 The shareholders’ resolutions are passed in meetings. Unless mandatory law prescribes another form, they can
also be passed outside meetings in writing (including e-mail or fax) or telephone voting if such procedure is requested by
a shareholder and no other shareholder declares its dissent with the procedure within two (2) weeks towards the board
of managers of the Company in written form. If no dissent is declared within the two (2) weeks pursuant to the foregoing
sentence the votes of the shareholders which are not participating in the voting shall be deemed to be abstention from
voting. Written resolutions must be signed by each shareholder and the written record must be sent to each shareholder
without undue delay. Resolutions not passed in writing must be confirmed in writing. Such confirmation only has decla-
ratory significance.
12.5 Unless a notarial record is made of shareholders’ resolutions, a written record must be made of every resolution
passed at shareholders’ meetings (for purposes of proof, not as a precondition of validity) without undue delay, which
must state the date and form of the resolution passed, the content of the resolution and the votes cast. The written
record must be sent to each shareholder in writing without undue delay.
12.6 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of
shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by
the sole shareholder.
Art. 13. General Meetings of Shareholders.
13.1 Meetings of shareholders may be held at the registered office of the Company or at such place and time as may
be specified in the respective convening notices of meeting.
13.2 The shareholders’ meeting is called by registered letter (registered personal delivery, registered delivery or
registered letter with confirmation of receipt) to each shareholder, stating the place, date, time and agenda, with a period
of notice of at least four (4) weeks for ordinary shareholders’ meetings and at least two (2) weeks for extraordinary
shareholders’ meetings. The period of notice begins to run on the day following postage. The day of the shareholders’
meeting is not counted in the calculation of the period of notice.
13.3 If all shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived convening
requirements, the meeting may be held without prior notice.
13.4 Each shareholder is entitled to be accompanied or represented at the shareholders’ meeting by another share-
holder authorised by a written power of attorney or by a lawyer, tax advisor or auditor under a professional duty of
confidentiality.
149792
L
U X E M B O U R G
13.5 Unless a notarial record is made of the negotiations of the shareholders’ meeting, a written record must be made
concerning the course of the meeting (for purposes of proof, not as a precondition of validity), which must state the place
and date of the meeting, the participants, the items on the agenda, the main content of the negotiations and the share-
holders’ resolutions. The written record must be signed by all shareholders present or represented in the shareholders’
meeting (for purposes of proof, not as a precondition of validity). Each shareholder must be sent a copy of the written
record.
Art. 14. Quorum and Vote.
14.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
14.2 A shareholders’ meeting only constitutes a quorum if at least fifty per cent (50%) of the share capital is represented.
Save for a higher majority provided in these articles of association or by Law, collective decisions of the Company’s
shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share
capital. If there is no quorum, a new shareholders’ meeting with the same agenda must be called without undue delay in
compliance with Article 13.2. This shareholders’ meeting then shall constitute a quorum regardless of the share capital
represented, if this was pointed out in the notice calling the meeting and the decisions shall be taken at the majority of
the votes cast.
Art. 15. Change of Nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous
consent.
Art. 16. Amendments of Articles of Association. Any amendment of these articles of association requires the approval
of (i) a majority in number of shareholders (ii) who are also a Super Majority.
Art. 17. Shareholders’ Resolutions Requiring Specific Majority.
17.1 Shareholders’ Resolutions regarding the following subjects must be taken by a Super Majority:
17.1.1 conclusion of intra-group agreements (Unternehmensverträge within the meaning of sections 291 et seqq.
German Stock Corporation Act (AktG));
17.1.2 conclusion of company participations (for the avoidance of doubt, other than by way of disposal of shares) of
any kind including silent partnerships and all agreements by which the other contractual party is granted a participation
in the Company’s profit or any payment that is dependent on the amount of the Company’s profit; this does not include
agreements with shareholders or employees of the Company, including agreements concluded in light of a prospective
status as shareholder or employee, as well as agreements with third parties within the ordinary course of business, e.g.
agreements between the Company and advertising partners.
17.2 Resolutions regarding the following subjects must be taken by a Super Majority and also require the prior consent
of the Investors:
17.2.1 material changes to the business object of the Company;
17.2.2 amendments of these articles of association;
17.2.3 merger, separation and transformation of the Company;
17.2.4 disposition of all Company’s assets or of a significant part of the Company’s assets including the resolution with
respect to the liquidation of the Company;
17.2.5 exclusion of subscription rights in case of capital increases;
17.2.6 acquisition of the Company’s own shares, with the exception of acquisitions in accordance with Article 9.2 and
transfers in accordance with Article 11.1 of these articles of association.
17.3. Whenever the capital of the Company is divided into different classes of shares the specific rights and obligations
attached to any class may be varied or abrogated with the unanimous consent in writing of the shareholders who hold
all the issued shares of that class.
D. Board of managers - Advisory board
Art. 18. Powers of the Sole Manager - Composition and Powers of the Board of Managers.
18.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers
form a board of managers.
18.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not
expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of
association is to be construed as a reference to the “sole manager”.
18.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any
actions necessary or useful to fulfil the Company’s corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the
Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.
Art. 19. Election, Removal and Term of Office of Managers.
19.1 The manager(s) shall be elected by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration
and term of office.
149793
L
U X E M B O U R G
19.2 The managers shall be elected and may be removed from office at any time, with or without cause.
19.3 The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two (2) different classes, being class A
managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant
shareholders resolutions and the managers be identified with respect to the class they belong.
Art. 20. Vacancy in the Office of a Manager.
20.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or
otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the replaced manager by the remaining managers until the next meeting of shareholders which shall resolve on the
permanent appointment, in compliance with the applicable legal provisions.
20.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company’s sole manager, such vacancy must be filled without undue
delay by the general meeting of shareholders.
Art. 21. Convening Meetings of the Board of Managers.
21.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held
at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.
21.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers at least twenty-four (24)
hours in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such document being
sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined
in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.
21.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive
any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of
managers.
Art. 22. Management.
22.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not
need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
22.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any
such meeting.
22.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either
in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.
22.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other
means of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis
and allowing an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a
participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.
22.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or
represented at a meeting of the board of managers.
22.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,
if any, shall not have a casting vote. In the event however the general meeting of shareholders has appointed different
classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only
be validly taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which
may be represented).
22.7 The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in
writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be
the date of the last signature.
22.8 The shareholders may by shareholders’ resolution adopt rules of procedure for the managers.
Art. 23. Minutes of the Meeting of the Board of Managers; Minutes of the Decisions of the Sole Manager.
23.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by
the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. In the event the general meeting of
shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers), such minutes
shall be signed by one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation). Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman,
if any, or by any two (2) managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of
managers (namely class A managers and class B managers), such copies or excerpts shall be signed by one (1) class A
manager and one (1) class B manager (including by way of representation).
149794
L
U X E M B O U R G
23.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.
Art. 24. Dealing with Third Parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the
signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers;
in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A manager
and class B manager), the Company will only be validly bound by the joint signature of at least one (1) class A manager
and one (1) class B manager (including by way of representation) or (ii) by the joint signatures or the sole signature of
any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such
delegation.
Art. 25. Advisory Board.
25.1 The Company shall have an advisory board. It shall consist of five (5) voting members. The shareholders’ meeting
may by way of a shareholders’ resolution increase or decrease the number of voting members of the advisory board.
25.2 The shareholders’ meeting shall only set and/or amend rules of procedure for the advisory board by way of a
unanimous shareholders’ resolution.
25.3 The voting members of the advisory board shall be nominated, withdrawn or replaced by each member’s res-
pective appointing shareholder by written notification towards the Company as follows:
25.3.1 Three (3) voting members of the advisory board shall be nominated by the shareholder Rocket in its sole
discretion;
25.3.2 One (1) voting member of the advisory board shall be nominated by the shareholder Access in its sole discretion;
and
25.3.3 One (1) voting member of the advisory board shall be nominated by the shareholder Aismare in its sole dis-
cretion.
25.4 The advisory board may have non-voting members of the advisory board as observers.
25.5 The advisory board shall have a chairman and a deputy chairman. A voting member nominated by Rocket shall
be the chairman of the advisory board. The rules of procedure of the advisory board may provide for further provisions
in particular on the self organization of the advisory board. The advisory board shall adopt resolutions with the simple
majority of votes cast. The advisory board shall hold meetings on a regular basis, at least once every calendar quarter.
25.6 The advisory board shall be competent for advising the Company’s managers on the strategy and operational
matters and shall discuss with the managers the budget of the Company.
25.7 The advisory board is not a supervisory board within the meaning of article 60bis-11 et seq. of the Law.
E. Audit and supervision
Art. 26. Auditor(s).
26.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company
shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.
26.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting
of shareholders.
26.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
26.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d’entreprises agréé
(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies’ register and the
accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.
26.5 An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its
approval.
F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends
Art. 27. Financial Year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end
on the thirty-first of December of the same year.
Art. 28. Annual Accounts and Allocation of Profits.
28.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of
the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.
28.2 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve.
This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten
per cent (10%) of the share capital of the Company.
28.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the
contributing shareholder agrees with such allocation.
149795
L
U X E M B O U R G
28.4 In case of a share capital reduction, the Company’s legal reserve may be reduced in proportion so that it does
not exceed ten per cent (10%) of the share capital.
28.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the
remainder of the Company’s annual net profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.
28.6 Subject to Article 8, distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they
hold in the Company.
Art. 29. Interim Dividends - Share Premium and Assimilated Premiums.
29.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared
by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed shall
be allocated where applicable in accordance with the provisions of Article 8 and Article 28.6 and may not exceed realized
profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable reserves, but decreased
by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles of association do not
allow to be distributed.
29.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the share-
holders subject to the provisions of the Law and these articles of association.
G. Liquidation
Art. 30. Liquidation. In the event of dissolution of the Company in accordance with Article 3.2 of these articles of
association, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting
of shareholders deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless other-
wise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realization of the assets and payment of the
liabilities of the Company.
H. Final clause - Governing law
Art. 31. Governing Law.
31.1 All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the Law and any
shareholders’ agreement which may be entered into from time to time between the shareholders and the Company, and
which may supplement certain provisions of these articles. Where any matter contained in these articles conflicts with
the provisions of any shareholders’ agreement, such shareholders’ agreement shall prevail inter partes and to the extent
permitted by Luxembourg law.
31.2 These articles are worded in English followed by a German translation; in case of divergence between the English
and the German text, the English version shall prevail.”
5. Miscellaneous.
Having duly considered each item of the agenda, the general meeting of shareholders unanimously takes the following
resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting of shareholders accepts Aismare, aforementioned, as new shareholder of the Company.
<i>Second resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves to increase the share capital of the Company by an amount of eight
hundred twenty-one euro (EUR 821) so as to raise it from its current amount of twenty-two thousand seven hundred
fifty euro (EUR 22,750) up to twenty-three thousand five hundred seventy-one euro (EUR 23,571) by issuing eight hundred
twenty-one (821) Series C Shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.
<i>Subscriptioni>
The eight hundred twenty-one (821) Series C Shares have been subscribed by Aismare, aforementioned, here repre-
sented as aforementioned, for the price of eight hundred twenty-one euro (EUR 821).
<i>Paymenti>
The eight hundred twenty-one (821) Series C Shares subscribed by Aismare, aforementioned, have been entirely paid
up through a contribution in cash in an amount of eight hundred twenty-one euro (EUR 821).
The amount of eight hundred twenty-one euro (EUR 821) is as now available to the Company as has been proved to
the undersigned notary.
The contribution in the amount of eight hundred twenty-one euro (EUR 821) is entirely allocated to the share capital.
<i>Third resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves the amendment of article five point one (5.1) of the articles of association
of the Company so that it shall now henceforth read as follows:
149796
L
U X E M B O U R G
" Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company’s share capital is set at twenty-three thousand five hundred seventy-one Euros (EUR 23,571.00),
represented by
5.1.1 twelve thousand five hundred (12,500) common shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each (he-
reinafter “Common Shares”),
5.1.2 eight thousand six hundred twenty-five (8,625) series A shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each
(hereinafter “Series A Shares”),
5.1.3 seven hundred eighty-six (786) series B shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each (hereinafter
“Series B Shares”) and
5.1.4 one thousand six hundred sixty (1,660) series C shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each
(hereinafter “Series C Shares”, the Series A Shares, the Series B Shares and the Series C Shares hereinafter also referred
to as “Preferred Shares”).
The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by these
articles of association or by the Law.”
<i>Fourth resolutioni>
Inter alia as a result of the foregoing, the general meeting of shareholders unanimously resolves to fully restate the
articles of association of the Company which shall henceforth read as set out in the agenda of the present deed.
There being no further business, the meeting is closed.
<i>Costs and expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are
estimated at approximately EUR 2,500.-
There being no further business, the meeting is closed.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-
ment.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,
the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing parties
and in case of divergence between the English and the German text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name
and residence, the said proxyholder signed together with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:
Im Jahre zweitausendvierzehn, am zehnten Juli.
Vor uns, dem unterzeichnenden Notar Maître Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxem-
burg,
SIND ERSCHIENEN:
1. Global Fin Tech Holding S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) ge-
gründet und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handelsund
Gesellschaftsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) unter der Nummer B 184.665, mit Sitz in 7, avenue J.P.
Pescatore, L-2324 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
Inhaber von zwölftausendvierhundertneunundneunzig (12.499) Stammanteilen und fünftausend (5.000) Anteilen der
Serie A der Gesellschaft,
hier vertreten durch Frau Alix van der Wielen, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht
ausgestellt am 2. Juli 2014 in Berlin, Deutschland und am 1. Juli 2014 in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg;
2. Bambino 53. V V UG (haftungsbeschränkt), eine Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) bestehend unter
deutschem Recht, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland, unter der Nummer
HRB 126893 B, mit Sitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Deutschland,
Inhaber eines (1) Stammanteils der Gesellschaft,
hier vertreten durch Frau Alix van der Wielen, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht
vom 2. Juli 2014, ausgestellt in Berlin, Deutschland;
3. Al Zencap Holdings LLC, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (limited liability company) nach dem Recht des
Bundesstaates Delaware, Vereinigte Staaten von Amerika, eingetragen beim Secretary of State des Bundesstaates Dela-
ware unter der Eintragungsnummer 5227608, mit Sitz in c/o Corporation Services Company, 2711 Centerville Road,
Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, Vereinigte Staaten von Amerika,
Inhaber von dreitausendsechshundertfünfundzwanzig (3.625) Anteilen der Serie A, siebenhundertsechsundachtzig
(786) Anteilen der Serie B und achthundertneununddreißig (839) Anteilen der Serie C der Gesellschaft,
149797
L
U X E M B O U R G
hier vertreten durch Frau Alix van der Wielen, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht
vom 30. Juni 2014, ausgestellt in New York, Vereinigte Staaten von Amerika;
4. Aismare Lux Holdings S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) gegründet
und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handelsund Gesell-
schaftsregister unter der Nummer B 176.544, mit Sitz in 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Großherzogtum
Luxemburg, mit einem Gesellschaftskapital von dreiundvierzigtausend Euro (EUR 43.000) („Aismare“), ausschließlich für
die Punkte 3 ff. der Tagesordnung teilnahme- und stimmberechtigt,
zukünftiger Inhaber von achthunderteinundzwanzig (821) Anteilen der Serie C der Gesellschaft,
hier vertreten durch Frau Alix van der Wielen, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht
vom 1. Juli 2014, ausgestellt in Munsbach, Großherzogtum Luxemburg.
Besagte Vollmachten, welche von der Bevollmächtigten der erschienenen Parteien und dem Notar ne varietur para-
phiert wurden, werden der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.
Die Parteien 1., 2. und 3. (die „Bestehenden Gesellschafter“) sind alle Gesellschafter der Zencap Global S.à r.l. (die
„Gesellschaft”), einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), gegründet und bestehend
unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Lu-
xemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 180.880, gegründet am
27. September 2013 gemäß einer Urkunde des Notars Maître Carlo Wersandt, mit Amtssitz in Luxemburg, welche am
25. November 2013 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 2968 veröffentlicht wurde. Die Satzung
der Gesellschaft wurde zuletzt am 14. Mai 2014 gemäß einer Urkunde des Notars Maître Henri Hellinckx, mit Amtssitz
in Luxemburg, geändert, welche noch nicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht wurde.
Da die Bestehenden Gesellschafter das gesamte Gesellschaftskapital vertreten und auf jegliche Ladungsformalitäten
verzichtet haben, ist die Gesellschafterversammlung ordnungsgemäß zusammengekommen und kann wirksam über die
folgende Tagesordnung verhandeln, wobei Aismare ausschließlich für die Punkte 3 ff. der Tagesordnung teilnahme- und
stimmberechtigt ist:
<i>Tagesordnungi>
1. Aufnahme von Aismare Lux Holdings S.à r.l., einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité
limitée) gegründet und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Han-
dels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 176.544, mit Sitz in 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach,
Großherzogtum Luxemburg, mit einem Gesellschaftskapital von dreiundvierzigtausend Euro (EUR 43.000), als neuer
Gesellschafter der Gesellschaft.
2. Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von zweiundzwanzigtausendsie-
benhundertfünfzig Euro (EUR 22.750) um einen Betrag von achthunderteinundzwanzig Euro (EUR 821) auf einen Betrag
von dreiundzwanzigtausendfünfhunderteinundsiebzig Euro (EUR 23.571) durch die Ausgabe von achthunderteinundzwan-
zig (821) Anteilen der Serie C mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1).
3. Anschließende Änderung des Artikels fünf Punkt eins (5.1) der Satzung der Gesellschaft, welcher nunmehr wie folgt
lautet:
„ Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt dreiundzwanzigtausendfünfhunderteinundsiebzig Euro (EUR
23.571,00), bestehend aus
5.1.1 zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteilen mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1) (die
„Stammanteile”),
5.1.2 achttausendsechshundertfünfundzwanzig (8.625) Anteilen der Serie A mit einem Nominalwert von je einem Euro
(EUR 1) (die „Anteile der Serie A”),
5.1.3 siebenhundertsechsundachtzig (786) Anteilen der Serie B mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1)
(die „Anteile der Serie B”), und
5.1.4 eintausendsechshundertsechzig (1.660) Anteilen der Serie C mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR
1) (die „Anteile der Serie C”, wobei die Anteile der Serie A, die Anteile der Serie B und die Anteile der Serie C im
Folgenden auch als „Vorzugsanteile“ bezeichnet werden).
Die mit den Anteilen verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es wird in dieser Satzung oder
durch das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.“
4. Gänzliche Neufassung der Satzung der Gesellschaft, welche nunmehr wie folgt lautet:
„A. Name - Zweck - Dauer - Sitz
Art. 1. Name. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen
Zencap Global S.à r.l. (die „Gesellschaft”), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handels-
gesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.
149798
L
U X E M B O U R G
Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Ge-
sellschaften, sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung
oder auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung,
Kontrolle und Entwicklung ihrer Beteiligungen.
2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder
Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören Garantien geben,
Sicherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.
2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere
durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren oder
Schuldtiteln, Schuldverschreibungen und Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheinen bzw. Wertpapie-
ren.
2.4 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur, sowie
solche, welche geistiges Eigentum oder Grundeigentum betreffen, vornehmen, die ihr zur Erreichung dieser Zwecke
förderlich erscheinen, im Hinblick auf deren Verwertung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Art.
Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden,
welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird.
Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Rates der Geschäftsführer
verlegt werden. Durch einen Gesellschafterbeschluss, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und
Weise gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.
4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer im
Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.
4.4 Sollte der Rat der Geschäftsführer entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale
Entwicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an
ihrem Gesellschaftssitz beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz bis zur endgültigen Beendigung dieser
außergewöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben
keine Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes
eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.
B. Gesellschaftskapital - Anteile
Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt dreiundzwanzigtausendfünfhunderteinundsiebzig Euro (EUR
23.571,00), bestehend aus
5.1.1 zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteilen mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1) (die
„Stammanteile”),
5.1.2 achttausendsechshundertfünfundzwanzig (8.625) Anteilen der Serie A mit einem Nominalwert von je einem Euro
(EUR 1) (die „Anteile der Serie A”),
5.1.3 siebenhundertsechsundachtzig (786) Anteilen der Serie B mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1)
(die „Anteile der Serie B”), und
5.1.4 eintausendsechshundertsechzig (1.660) Anteilen der Serie C mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR
1) (die „Anteile der Serie C”, wobei die Anteile der Serie A, die Anteile der Serie B und die Anteile der Serie C im
Folgenden auch als „Vorzugsanteile“ bezeichnet werden).
Die mit den Anteilen verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es wird in dieser Satzung oder
durch das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.
5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-
zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.
5.3 Jede der Gesellschaften (i) Global Fin Tech Holding S.à r.l. („Rocket“), (ii) Al Zencap Holdings LLC („Access“) und
Aismare Lux Holdings S.à r.l. („Aismare“; Rocket, Access und Aismare gemeinschaftlich die „Investoren“ und jeweils ein
„Investor“) ist zur Zeichnung einer Anzahl weiterer bei einer Kapitalerhöhung ausgegebener Anteile berechtigt, wodurch
ein Investmentangebot eines Dritten umgesetzt wird (bei dem es sich weder um einen Gesellschafter, noch um eine mit
einem Gesellschafter verbundene Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG) (ein „Drittin-
vestor“) handelt), der mit einer Qualifizierten Mehrheit zugestimmt wurde (eine „Investition eines Dritten“) - unabhängig
davon, ob diese vom Drittinvestor oder von einem oder mehreren vergleichbaren Gesellschaftern erfolgte - und die zur
Erhaltung der Beteiligungsquote an der Gesellschaft vor einer solchen Kapitalerhöhung erforderlich ist, und dies zu den-
149799
L
U X E M B O U R G
selben Bedingungen, wie bei einer Investition eines Dritten. Der jeweilige Investor hat die Gesellschaft durch eine
verbindliche Erklärung innerhalb von drei (3) Wochen darüber zu unterrichten, ob er sein Recht gemäß des vorstehenden
Satzes dieses Artikels 5.3 ausüben möchte, wobei die Investition eines Dritten nach Ablauf dieser Frist (soweit nicht von
den Investoren nach diesem Artikel 5.3 übernommen) durchgeführt wird.
Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit jeweils dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht über-
schreiten darf.
6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs, die Insolvenz
oder ein vergleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.
6.5 Die Gesellschaft kann Einlagen ohne Ausgabe von Anteilen oder anderen Sicherheiten als Gegenleistung annehmen
und diese einer oder mehreren ausschüttbaren Rücklagen zuführen. Entscheidungen bezüglich der Verwendung solcher
ausschüttbarer Rücklagen werden gegebenenfalls von dem(den) Gesellschafter(n) oder Geschäftsführer(n) unter Berück-
sichtigung des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung getroffen.
Art. 7. Anteilsregister - Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden
kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.
7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten
wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft
ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.
7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.
7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern, die
drei Viertel des Gesellschaftskapitals halten und vorbehaltlich der Bestimmungen von Gesellschaftervereinbarungen zwi-
schen den Gesellschaftern, sofern vorhanden, insbesondere vorbehaltlich Vorkaufsrechten, Bezugsrechten oder Mitver-
kaufsrechten- oder Pflichten aus Gesellschaftervereinbarungen zwischen den Gesellschaftern übertragen werden. Sofern
eine solche Zustimmung erteilt wurde, ist eine weitere Einwilligung zur Übertragung von Anteilen nicht erforderlich:
7.4.1 bei einer Übertragung, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen durch einen Investor an
eine mit dem betreffenden Investor verbundene Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG);
7.4.2 bei einem Verkauf, einer Übertragung, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen durch
einen Investor an eine Gesellschaft, (x) welche direkt oder indirekt (i) diesen Investor oder (ii) einen oder mehrere direkte
oder indirekte Gesellschafter des betreffenden Investors (jeweils eine „Kontrollierte Gesellschaft“) Kontrolliert, von
diesem Kontrolliert Wird, oder unter der gemeinsamen Kontrolle von diesem steht, wobei die Worte „Kontrolle“ oder
„Kontrolliert Wird“ oder „Kontrolliert“ die direkte oder indirekte Beherrschung der Gesellschaft bezeichnet, durch (a)
die Leitung der Gesellschaft als geschäftsführender Gesellschafter, (b) das Halten der Mehrheit der Anteile oder (c) das
Halten der Mehrheit der Stimmrechte durch eine vertragliche Stimmvereinbarung, oder (d) die einseitige Fähigkeit, direkt
oder indirekt die Leitung der Geschäftsführung und Handlungsweisen einer Person, entweder durch das Halten stimm-
berechtigter Wertpapiere oder anderweitig, zu beeinflussen, oder (y) in welcher der betreffende Investor oder ein oder
mehrere Gesellschafter dieses Investors eine direkte oder indirekte Mehrheitsbeteiligung haben;
7.4.3 bei einer Übertragung, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen (i) an einen Dritten,
welcher Anteile unter der vereinfachten Mitarbeiterbeteiligung erwirbt, oder (ii) an die Gesellschaft und/oder einen
beliebigen Investor gemäß einer Call-Option im Zusammenhang mit einer Vesting-Regelung.
7.5 In den in Artikel 7.4.1 bis 7.4.3 vorgesehenen Fällen gelten weder Verpflichtungen zu Verkaufsangeboten, noch
Vorkaufsrechte, Bezugsrechte oder Mitverkaufsrechte- oder Pflichten zugunsten anderer Gesellschafter.
7.6 Eine Übertragung, eine Abtretung oder eine andere Veräußerung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft
und Dritten gemäß Artikel 1690 des Code Civil wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung, Abtretung oder
anderen Veräußerung in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung, Abtretung oder anderen Veräußerung zugestimmt
hat.
7.7 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters nur an neue Gesellschafter übertragen werden,
wenn Gesellschafter, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals (eine „Qualifizierte Mehrheit“) halten, einer
solchen Übertragung zustimmen (wobei die Anteile des verstorbenen Gesellschafters für diese Zwecke nicht berück-
sichtigt werden). Eine derartige Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn die Anteile an Eltern, Nachkommen oder den/
die überlebende/n Ehepartner/in oder jeden anderen gesetzlichen Erben des verstorbenen Gesellschafters übertragen
werden.
149800
L
U X E M B O U R G
Art. 8. Liquidations- und Verkaufspräferenzen.
8.1 Im Falle (i) eines Verkaufs von mindestens fünfzig Prozent (50%) aller Anteile an der Gesellschaft oder eines
Tausches oder einer Übernahme der Gesellschaft in wirtschaftlich vergleichbarer Weise in einer oder mehreren ver-
bundenen Transaktionen oder in zeitlicher Nähe zueinander, oder (ii) der Liquidation der Gesellschaft oder (iii) eines
Verkaufs oder einer Übertragung von Anteilen an der Gesellschaft entweder an Dritte oder an andere Gesellschafter,
was dazu führen würde, dass entweder mehr als fünfzig Prozent (50%) des Gesellschaftskapitals oder mehr als fünfzig
Prozent (50%) der Stimmrechte im Besitz der erwerbenden Partei bzw. Parteien wären (change of control), als Ergebnis
eines oder mehrerer verbundener Akquisitionen, (wobei jeder der unter (i), (ii) und (iii) beschriebenen Fälle im Folgenden
als „Liquiditätsereignis“ bezeichnet wird), werden die Erlöse („Exiterlöse“) - vorbehaltlich der Artikel 8.2 bis 8.4 - im
Einklang mit Artikel 8.5 auf einer pro rata-Basis entsprechend ihrer Beteiligung am Liquiditätsereignis an die Gesellschafter
verteilt.
8.2 Auf einer ersten Ebene („Erste Ebene”) erhalten die Inhaber von Anteilen der Serie C einen Betrag, welcher dem
Betrag ihrer jeweiligen Gesamtinvestition in die Gesellschaft entspricht (bestehend aus dem Nominalbetrag der von
diesem Inhaber erworbenen Anteile der Serie C und dem Agio und/oder anderen Kapitaleinlage (Konto 115 des Stan-
dardisierten Luxemburgischen Kontenplans), die von diesem Inhaber an die Gesellschaft gezahlt wurden). Sind nicht
ausreichend Exiterlöse für die Zahlungen auf der PAGE 32 Ersten Ebene vorhanden, so werden die Exiterlöse an die
Inhaber der Anteile der Serie C auf einer pro-rata Basis zu den Beträgen verteilt, die an die Inhaber der Anteile der Serie
C auf der Ersten Ebene verteilt worden wären, wenn ausreichend Exiterlöse vorhanden gewesen wären.
8.3 Auf einer zweiten Ebene („Zweite Ebene”) erhalten die Inhaber von Anteilen der Serie B einen Betrag, welcher
dem Betrag ihrer jeweiligen Gesamtinvestition in die Gesellschaft entspricht (bestehend aus dem Nominalbetrag der von
diesem Inhaber erworbenen Anteile der Serie B und dem Agio und/oder anderen Kapitaleinlage (Konto 115 des Stan-
dardisierten Luxemburgischen Kontenplans), die von diesem Inhaber an die Gesellschaft gezahlt wurden). Sind nicht
ausreichend Exiterlöse für die Zahlungen auf der Zweiten Ebene vorhanden, so werden die Exiterlöse an die Inhaber der
Anteile der Serie B auf einer pro-rata Basis zu den Beträgen verteilt, die an die Inhaber der Anteile der Serie B auf der
Zweiten Ebene verteilt worden wären, wenn ausreichend Exiterlöse vorhanden gewesen wären.
8.4 Auf einer dritten Ebene („Dritte Ebene”) erhalten die Inhaber von Anteilen der Serie A einen Betrag, welcher dem
Betrag ihrer jeweiligen Gesamtinvestition in die Gesellschaft entspricht (bestehend aus dem Nominalbetrag der von
diesem Inhaber erworbenen Anteile der Serie A und dem Agio und/oder anderen Kapitaleinlage (Konto 115 des Stan-
dardisierten Luxemburgischen Kontenplans), die von diesem Inhaber an die Gesellschaft gezahlt wurden). Sind nicht
ausreichend Exiterlöse für die Zahlungen auf der Vorzugsebene vorhanden, so werden die Exiterlöse an die Inhaber der
Anteile der Serie A auf einer pro-rata Basis zu den Beträgen verteilt, die an die Inhaber der Anteile der Serie A auf der
Vorzugsebene verteilt worden wären, wenn ausreichend Exiterlöse vorhanden gewesen wären.
8.5 Nachdem die Zahlungen auf der Ersten, Zweiten und Dritten Ebene geleistet wurden, werden die übrigen Exiterlöse
auf einer gemeinsamen Ebene („Gemeinsame Ebene“) an alle Gesellschafter auf einer pro rata-Basis entsprechend ihrer
Beteiligung am Liquiditätsereignis verteilt. Sämtliche von einem Gesellschafter auf der Ersten, Zweiten und Dritten Ebene
erhaltenen Beträge mindern den von diesem Gesellschafter zu erhaltenden Betrag auf der Gemeinsamen Ebene und
werden anschließend entsprechend dieser Gemeinsamen Ebene zugeteilt, mit der Maßgabe, dass kein Gesellschafter zur
Rückzahlung eines auf der Ersten, Zweiten und Dritten Ebene erhaltenen Betrags verpflichtet ist. Die Zuteilung auf der
Gemeinsamen Ebene erfolgt solange, bis alle Exiterlöse an die Gesellschafter verteilt wurden. Unabhängig davon, ob der
Verkauf von Anteilen während eines Liquiditätsereignisses oder danach in einer oder mehreren Transaktionen erfolgt
oder nicht, hat kein Gesellschafter für den Verkauf all seiner Anteile einen Betrag zu erhalten (und übersteigende Beträge
an die anderen Gesellschafter zurückzuzahlen), der höher ist, (i) als sein Anteil an der Gesamtheit der Exiterlöse oder
Erlöse auf einer pro rata-Basis zu den Anteilen, die auf einer gemeinsamen und gleichwertigen Basis verkauft wurden oder
(ii) als der Betrag, der diesem Gesellschafter auf der Ersten, Zweiten und Dritten Ebene aus einem späteren Verkauf
zugeteilt wurde. Sämtliche mit der hierin festgelegten Liquiditätspräferenz verbundenen Rechte können nur einmal aus-
geübt werden.
8.6 Die bevorzugte Zuteilung auf der Ersten, Zweiten und Dritten Ebene gilt für alle entsprechenden Vorzugsanteile
solange, wie bei den jeweiligen Vorzugsanteilen der jeweils in Artikel 8.2 festgelegte Betrag noch nicht verteilt wurde.
Art. 9. Rückkauf von Anteilen.
9.1 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen. Die Stimmrechte der von der Gesellschaft gehaltenen
Anteile werden so lange ausgesetzt, wie die Anteile von der Gesellschaft gehalten werden.
9.2 Anteile eines Gesellschafters können ohne Zustimmung eines solchen zurückgekauft werden, wenn:
9.2.1 ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des Gesellschafters eröffnet wird oder die Eröffnung eines Insolvenz-
verfahrens mangels Masse abgelehnt wird;
9.2.2 der Anteil des Gesellschafters gepfändet wurde oder Vollstreckungsverfahren anderweitig gegen diesen Anteil
eingeleitet wurden und diese Verfahren nicht innerhalb von zwei (2) Monaten vollständig eingestellt sind.
Mit Erhalt durch den Gesellschafter der vom Rat der Geschäftsführer gesendeten Rückkaufserklärung sind die Anteile
automatisch zurückgekauft, ohne dass es einer weiteren Handlung bedarf. Die vorliegende Satzung stellt gemeinsam mit
der Rückkaufserklärung ein gültiges Dokument im Sinne des Artikels 190 des Gesetzes von 1915 dar und die Gesellschaft
149801
L
U X E M B O U R G
bestätigt hiermit die Kenntnisnahme der Übertragung der Anteile, akzeptiert diese und verpflichtet sich zur Eintragung
dieser Übertragung in ihrem Anteilsregister und zur entsprechenden gesetzlich geforderten Hinterlegung für diesen Fall.
9.3 Wird der Anteil von mehreren Personen gehalten, ist das Vorliegen eines Grundes zum Rückkauf in Bezug auf eine
Person ausreichend; unabhängig davon können mehrere gemeinschaftlich berechtigte Personen die Gesellschafterrechte
nur dann und einheitlich ausüben, wenn eine der gemeinschaftlich berechtigten Personen unverzüglich nach Eintritt der
gemeinschaftlichen Berechtigung zu diesem Zwecke ernannt wird.
9.4 Ein Rückkauf kann durch den Rat der Geschäftsführer erklärt werden. Die Rückkaufserklärung wird wirksam, sobald
der betreffende Gesellschafter die Erklärung erhält und ein entsprechender Gesellschafterbeschluss gefasst wird (außer
im Falle von Artikel 9.2 dieser Satzung, in welchem keine Erklärung des Gesellschafters und kein entsprechender Gesell-
schafterbeschluss erforderlich sind).
Art. 10. Ausgleichszahlung für den Rückkauf.
10.1 Der Rückkauf erfolgt gegen eine Ausgleichszahlung.
10.2 Die Ausgleichszahlung besteht aus einem Gesamtbetrag, welcher dem Marktwert der zurückgekauften Anteile
entspricht. Als Stichtag gilt der Tag vor dem Rückkaufsbeschluss.
10.3 Die Ausgleichszahlung für den Rückkauf ist unmittelbar mit dem Rückkauf der Anteile fällig und zahlbar.
10.4 Der ausscheidende Gesellschafter ist nicht dazu befugt, von der Gesellschaft Sicherheiten für ausstehende Beträge
zuzüglich Zinsen zu verlangen.
10.5 Bei Streitigkeiten hinsichtlich des Betrags der zu zahlenden Ausgleichszahlung für den Rückkauf ist diese Aus-
gleichszahlung von einem Wirtschaftsprüfer in der Eigenschaft als Schiedsgutachter, der von den Gesellschaftern gemein-
schaftlich ernannt wird, festzulegen. Wird über die Ernennung des Schiedsgutachters keine Einigung erzielt, so wird dieser
auf Ersuchen eines Gesellschafters oder der Gesellschaft vom Vorsitzenden des Bezirksgerichts (Tribunal d’Arrondisse-
ment) bestimmt. Die Entscheidung des Schiedsgutachters ist bindend. Die Kosten für das Gutachten werden von der
Gesellschaft und dem betreffenden Gesellschafter zu gleichen Teilen getragen, wobei der vom Gesellschafter zu tragende
Teil mit der Ausgleichszahlung für den Rückkauf verrechnet und die Ausgleichszahlung für den Rückkauf dementsprechend
herabgesetzt wird. Der Gesellschafter hat die übrigen Kosten zu tragen, sofern der Rückkaufspreis die dem Gesellschafter
zugewiesenen Kosten für das Gutachten nicht deckt.
Art. 11. Abtretung anstelle von Rückkauf.
11.1 Die Gesellschaft kann entscheiden, dass der betreffende Gesellschafter anstelle des Rückkaufs die Anteile an eine
von der Gesellschaft benannte Person (einschließlich eines anderen Gesellschafters) zu übertragen hat, auch im Falle eines
Teilrückkaufs oder einer Teilabtretung der Anteile an die Gesellschaft oder an eine von der Gesellschaft benannte Person.
11.2 Der vorliegende Artikel 11 gilt mit der Maßgabe, dass, wie in Artikel 10 dieser Satzung vorgesehen, die Aus-
gleichszahlung für die abzutretenden Anteile durch die die Anteile erwerbende Person geschuldet ist und dass die
Gesellschaft als Garant haftet.
C. Entscheidungen der Gesellschafter
Art. 12. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
12.1 Die Gesellschafterversammlung ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch das Gesetz und diese Satzung
ausdrücklich vorbehalten sind.
12.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.
12.3 Falls und solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, dürfen gemeinsame
Entscheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung vorbehalten wären, schriftlich gefasst werden. In die-
sem Fall erhält jeder Gesellschafter den Text der zu fassenden Beschlüsse oder Entscheidungen in ausformulierter Form
und übt sein Stimmrecht schriftlich aus.
12.4 Gesellschafterbeschlüsse werden in Versammlungen gefasst. Sofern nicht zwingende gesetzliche Vorschriften eine
andere Form vorschreiben, können sie auch außerhalb von Versammlungen in schriftlicher Form (einschließlich EMail
oder Fax) oder durch telefonische Abstimmung gefasst werden, sofern ein solches Verfahren von einem Gesellschafter
ersucht wird und kein anderer Gesellschafter innerhalb von zwei (2) Wochen in schriftlicher Form Widerspruch gegen
dieses Verfahren gegenüber dem Rat der Geschäftsführer der Gesellschaft einlegt. Wird innerhalb von zwei (2) Wochen
kein Widerspruch gemäß des vorstehenden Satzes eingelegt, so werden die Stimmen der nicht an der Abstimmung teil-
nehmenden Gesellschafter als Enthaltungen gewertet. Schriftliche Beschlüsse sind von jedem Gesellschafter zu unter-
zeichnen und die Niederschrift ist jedem Gesellschafter unverzüglich zuzusenden. Beschlüsse, welche nicht in schriftlicher
Form gefasst werden, sind schriftlich zu bestätigen. Eine solche Bestätigung hat ausschließlich feststellende Bedeutung.
12.5 Von jedem Beschluss, der in Gesellschafterversammlungen gefasst wurde, ist unverzüglich eine Niederschrift
anzufertigen (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die Wirksamkeit), die das Datum und die Form des gefassten
Beschlusses, den Inhalt des Beschlusses und die abgegebenen Stimmen zu enthalten hat, es sei denn, die Gesellschafter-
beschlüsse wurden notariell beurkundet. Die Niederschrift muss jedem Gesellschafter unverzüglich in schriftlicher Form
zugesendet werden.
149802
L
U X E M B O U R G
12.6 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschriften
des Abschnitts XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jede Bezugnahme auf die „Gesell-
schafterversammlung“ in der vorliegenden Satzung als Bezugnahme auf den Alleingesellschafter, je nach Zusammenhang
und soweit anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingesellschafter
ausgeübt.
Art. 13. Gesellschafterversammlung.
13.1 Gesellschafterversammlungen finden am Sitz der Gesellschaft oder an einem Ort und zu einer Zeit statt, welche
in der entsprechenden Einladung genauer bestimmt werden.
13.2 Die Gesellschafterversammlung wird mittels Einschreiben (Zustellung zu eigenen Händen, Einschreiben oder
Einschreiben mit Rückschein) an jeden Gesellschafter einberufen und beinhaltet den Ort, das Datum, die Uhrzeit und die
Tagesordnung, wobei bei ordentlichen Gesellschafterversammlungen eine Ankündigungsfrist von mindestens vier (4)
Wochen und bei außerordentlichen Gesellschafterversammlungen eine Ankündigungsfrist von mindestens zwei (2) Wo-
chen einzuhalten ist. Die Ankündigungsfrist beginnt am Tag nach dem Versand. Der Tag der Gesellschafterversammlung
wird bei der Berechnung der Ankündigungsfrist nicht berücksichtigt.
13.3 Falls alle Gesellschafter in einer Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten sind und auf Einladungs-
formalitäten verzichtet haben, kann die Versammlung auch ohne vorherige Ankündigung abgehalten werden.
13.4 Jeder Gesellschafter ist dazu berechtigt, bei der Gesellschafterversammlung von einem anderen durch eine
schriftliche Vollmacht dazu berechtigten Gesellschafter oder von einem Anwalt, Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer
unter der Berufsverschwiegenheitspflicht begleitet oder vertreten zu werden.
13.5 Eine Niederschrift hinsichtlich des Ablaufs der Versammlung ist (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die
Wirksamkeit) anzufertigen und hat den Ort und das Datum der Versammlung, die Teilnehmer, die Tagesordnungspunkte,
den Hauptinhalt der Verhandlungen und die Gesellschafterbeschlüsse zu beinhalten, es sei denn, die Verhandlungen der
Gesellschafterversammlung wurden notariell beurkundet.
Die Niederschrift ist von allen bei der Gesellschafterversammlung anwesenden oder vertretenen Gesellschaftern zu
unterzeichnen (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die Wirksamkeit). Jedem Gesellschafter ist eine Kopie der
Niederschrift zuzusenden.
Art. 14. Quorum und Abstimmung.
14.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.
14.2 Eine Gesellschafterversammlung ist nur dann beschlussfähig, wenn mindestens fünfzig Prozent (50%) des Gesell-
schaftskapitals vertreten sind. Vorbehaltlich anderer Regelungen dieser Satzung oder des Gesetzes von 1915, die ein
höheres Mehrheitsverhältnis vorsehen, bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von
Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals innehaben. Bei Beschlussunfähigkeit ist unverzüglich im
Einklang mit Artikel 13.2 eine neue Gesellschafterversammlung mit derselben Tagesordnung einzuberufen. Diese Gesell-
schafterversammlung ist dann unabhängig von dem vertretenen Gesellschaftskapital beschlussfähig, sofern darauf in der
die Versammlung einberufenden Ladung hingewiesen wurde und Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen
Stimmen gefasst.
Art. 15. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.
Art. 16. Änderung der Satzung. Eine Änderung dieser Satzung erfordert die Zustimmung (i) einer zahlenmäßigen
Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die gleichzeitig eine Qualifizierte Mehrheit darstellen.
Art. 17. Beschlüsse, die eine spezifische Mehrheit erfordern.
17.1 Gesellschafterbeschlüsse hinsichtlich der folgenden Angelegenheiten erfordern eine Qualifizierte Mehrheit:
17.1.1 Abschluss von Unternehmensverträgen (im Sinne der §§ 291 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG));
17.1.2 Abschluss von Unternehmensbeteiligungen (um Zweifel auszuschließen, nicht durch die Veräußerung von An-
teilen) jeglicher Art einschließlich stiller Beteiligungen und sämtlicher Verträge, durch welche die andere Vertragspartei
eine Beteiligung am Gewinn der Gesellschaft erhält oder jede Zahlung, welche vom Gewinnbetrag der Gesellschaft ab-
hängig ist; dies umfasst nicht Verträge mit Gesellschaftern oder Angestellten der Gesellschaft, einschließlich Verträge,
welche im Hinblick auf einen voraussichtlichen Status als Gesellschafter oder Angestellter abgeschlossen wurden, sowie
Verträge mit Dritten innerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs, z.B. Verträge zwischen der Gesellschaft und Werbe-
partnern.
17.2 Beschlüsse hinsichtlich der folgenden Angelegenheiten erfordern eine Qualifizierte Mehrheit und zudem die vor-
herige Zustimmung der Investoren:
17.2.1 Wesentliche Änderungen des Geschäftszwecks der Gesellschaft;
17.2.2 Änderungen dieser Satzung;
17.2.3 Verschmelzung, Ausgliederung und Umwandlung der Gesellschaft;
17.2.4 Veräußerung des gesamten Gesellschaftsvermögens oder eines beträchtlichen Anteils des Gesellschaftsvermö-
gens einschließlich des Beschlusses hinsichtlich der Liquidation der Gesellschaft;
149803
L
U X E M B O U R G
17.2.5 Ausschluss von Bezugsrechten im Falle von Kapitalerhöhungen;
17.2.6 Erwerb eigener Anteile der Gesellschaft, mit Ausnahme der Erwerbe gemäß Artikel 9.2 und Übertragungen
gemäß Artikel 11.1 dieser Satzung.
17.3 Ist das Gesellschaftskapital in verschiedene Anteilsklassen unterteilt, so können die spezifischen Rechte und
Pflichten im Zusammenhang mit einer Anteilsklasse mit der einstimmigen und schriftlichen Zustimmung der Gesellschaf-
ter, die alle ausgegebenen Anteile dieser Anteilsklasse halten, verändert oder aufgehoben werden.
D. Rat der Geschäftsführer - Beirat
Art. 18. Befugnisse des Alleinigen Geschäftsführers -Zusammensetzung und Befugnisse des Rates der Geschäftsführer.
18.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Ge-
schäftsführer hat, bilden diese einen Rat der Geschäftsführer.
18.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „alleiniger Ge-
schäftsführer“ nicht ausdrücklich in dieser Satzung verwendet wird, ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Rat der
Geschäftsführer“ als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer“ auszulegen.
18.3 Der Rat der Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, im Namen der Gesellschaft zu handeln
und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.
Art. 19. Ernennung, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
19.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung ernannt, welche ihre Bezüge und
ihre Amtszeit festlegt.
19.2 Die Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund ernannt oder abberufen werden.
19.3 Die Gesellschafterversammlung kann die Ernennung von Geschäftsführern zwei (2) unterschiedlicher Kategorien
beschließen, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Eine solche Klassifizierung
der Geschäftsführer muss ordnungsgemäß in der Niederschrift des betreffenden Gesellschafterbeschlusses festgehalten
und die Geschäftsführer der Kategorie, der sie angehören, zugeordnet werden.
Art. 20. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
20.1 Scheidet ein Geschäftsführer durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Insolvenz, Rücktritt oder aus einem anderem
Grund aus seinem Amt aus, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen
die ursprüngliche Amtszeit des ersetzten Geschäftsführers nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesell-
schafterversammlung ausgefüllt werden, welche im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die
endgültige Ernennung entscheidet.
20.2 Für den Fall, dass der alleinige Geschäftsführer aus seinem Amt ausscheidet, muss die frei gewordene Stelle
unverzüglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.
Art. 21. Einladung zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
21.1 Der Rat der Geschäftsführer versammelt sich auf Einberufung durch einen Geschäftsführer. Die Sitzungen des
Rates der Geschäftsführer finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.
21.2 Die Geschäftsführer werden mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung anberaumten
Zeitpunkt zu jeder Sitzung des Rates der Geschäftsführer schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe
der Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Geschäftsführer
per Post, Fax, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abgegeben haben, wobei
eine Kopie eines solchen Dokuments ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung zu Sitzungen des Rates der Ge-
schäftsführer ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss des Rates der Geschäftsführer
bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.
21.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle
Einladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Rates
der Geschäftsführer diesen zustimmen und diese unterzeichnen.
Art. 22. Geschäftsführung.
22.1 Der Rat der Geschäftsführer kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Rat der Ge-
schäftsführer kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise selbst ein Geschäftsführer sein muss
und der für die Protokollführung der Sitzungen des Rates der Geschäftsführer verantwortlich ist.
22.2 Sitzungen des Rates der Geschäftsführer werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Rates der Ge-
schäftsführer geleitet. In dessen Abwesenheit kann der Rat der Geschäftsführer einen anderen Geschäftsführer durch
einen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Mitglieder als Vorsitzenden pro tempore ernennen.
22.3 Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer teilnehmen, indem er einen anderen
Geschäftsführer schriftlich oder durch Faxschreiben, per E-Mail oder durch ein anderes vergleichbares Kommunikati-
onsmittel bevollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Geschäftsführer
kann einen oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.
149804
L
U X E M B O U R G
22.4 Eine Sitzung des Rates der Geschäftsführer kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein
anderes Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu
hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel
ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung gilt als am Sitz der Ge-
sellschaft abgehalten.
22.5 Der Rat der Geschäftsführer kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest eine Mehrheit der
Geschäftsführer in einer Sitzung anwesend oder vertreten ist.
22.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Rates der Geschäftsführer
teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden,
hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme. Sofern die Gesellschafterversammlung allerdings un-
terschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäfts-
führer der Kategorie B), werden Beschlüsse des Rates der Geschäftsführer nur dann wirksam gefasst, wenn sie von der
Mehrheit der Geschäftsführer einschließlich mindestens eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsfüh-
rers der Kategorie B (oder deren Vertreter) gefasst werden.
22.7 Der Rat der Geschäftsführer kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung,
per Faxschreiben, per E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Jeder Geschäftsführer kann
seine Zustimmung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreff-
enden Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.
22.8 Die Gesellschafter können durch einen Gesellschafterbeschluss eine Geschäftsordnung für die Geschäftsführer
beschließen.
Art. 23. Protokoll von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer; Protokoll der Entscheidungen des Alleinigen Ge-
schäftsführers.
23.1 Das Protokoll einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer wird vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer,
falls vorhanden oder, im Falle seiner Abwesenheit, vom Vorsitzenden pro tempore und dem Schriftführer (falls vorhan-
den), oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unterschied-
liche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der
Kategorie B), werden Protokolle von einem (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einem (1) Geschäftsführer der
Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsver-
fahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer, falls
vorhanden, oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden solche Kopien oder Auszüge von einem (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einem (1)
Geschäftsführer der Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet.
23.2 Die Entscheidungen des alleinigen Geschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom alleinigen
Geschäftsführer unterzeichnet wird. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet.
Art. 24. Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Um-
ständen (i) durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder, für den Fall, dass die Gesellschaft mehrere
Geschäftsführer hat, durch die gemeinsamen Unterschriften zwei (2) beliebiger Geschäftsführer wirksam verpflichtet;
sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäfts-
führer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B), wird die Gesellschaft nur durch die gemeinsamen
Unterschriften mindestens eines (1) Geschäftsführers der Kategorie A und eines (1) Geschäftsführers der Kategorie B
(oder deren Vertreter), oder (ii) durch die gemeinsamen Unterschriften oder die alleinige Unterschrift jedweder Person
(en), der/denen eine Unterschriftsbefugnis durch den Rat der Geschäftsführer übertragen worden ist, wirksam verpflich-
tet.
Art. 25. Beirat.
25.1 Die Gesellschaft hat einen Beirat. Dieser besteht aus fünf (5) stimmberechtigten Mitgliedern. Die Gesellschafter-
versammlung kann durch einen Gesellschafterbeschluss die Anzahl der stimmberechtigten Mitglieder des Beirats erhöhen
oder herabsetzen.
25.2 Die Gesellschafterversammlung kann die Geschäftsordnung für den Beirat nur durch einen einstimmigen Gesell-
schafterbeschluss festlegen und/oder verändern.
25.3 Die stimmberechtigten Mitglieder des Beirats werden von dem entsprechenden ernennenden Gesellschafter jedes
Mitglieds durch schriftliche Mitteilung an die Gesellschaft wie folgt ernannt, abberufen oder ersetzt:
25.3.1 Drei (3) stimmberechtigte Mitglieder des Beirats werden von dem Gesellschafter Rocket nach eigenem Ermes-
sen ernannt;
25.3.2 Ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats wird von dem Gesellschafter Access nach eigenem Ermessen
ernannt; und 25.3.3 Ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats wird von dem Gesellschafter Aismare nach eigenem
Ermessen ernannt.
149805
L
U X E M B O U R G
25.4 Der Beirat kann nicht-stimmberechtigte Mitglieder als Beobachter haben.
25.5 Der Beirat hat einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden. Ein von Rocket ernanntes stimm-
berechtigtes Mitglied ist der Vorsitzende des Beirats. Die Geschäftsordnung des Beirats hat weitere Bestimmungen,
insbesondere hinsichtlich der Selbstorganisation des Beirats, zu enthalten. Der Beirat fasst Beschlüsse mit einfacher
Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Der Beirat hält regelmäßig Sitzungen ab, mindestens einmal pro Kalenderquartal.
25.6 Der Beirat ist für die Beratung der Geschäftsführer der Gesellschaft hinsichtlich Strategie und operativer Ange-
legenheiten zuständig und berät mit den Geschäftsführern über den Haushalt der Gesellschaft.
25.7 Der Beirat ist kein Aufsichtsrat im Sinne des Artikels 60bis-11 ff. des Gesetzes von 1915.
E. Aufsicht und Prüfung der Gesellschaft
Art. 26. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
26.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der
Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)). Die Gesellschafterversammlung
ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.
26.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
26.3 Die Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Recht der permanenten Überprüfung und Kontrolle aller Ge-
schäfte der Gesellschaft.
26.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember
2002 betreffend das Handelsregister und die Buchhaltung und den Jahresabschluss von Unternehmen, in der jeweils
gültigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d’entreprises agréé(s)) ernennen, entfällt
die Funktion des Rechnungsprüfers.
26.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die
Gesellschafterversammlung abberufen werden.
F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinnverwendung – Abschlagsdividenden
Art. 27. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am
einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.
Art. 28. Jahresabschluss und Gewinne.
28.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Rat der Geschäftsführer erstellt im
Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und
Verlustrechnung.
28.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage
der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.
28.3 Durch einen Gesellschafter erbrachte Einlagen in Rücklagen können mit Zustimmung dieses Gesellschafters
ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.
28.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage der Gesellschaft verhältnis-
mäßig herabgesetzt werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.
28.5 Auf Vorschlag des Rates der Geschäftsführer bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den Be-
stimmungen des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung, wie der verbleibende jährliche Nettogewinn der Gesellschaft
verwendet werden soll.
28.6 Vorbehaltlich des Artikels 8 erfolgen Ausschüttungen an die Gesellschafter proportional zur Anzahl der von ihnen
an der Gesellschaft gehaltenen Anteile.
Art. 29. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
29.1 Der Rat der Geschäftsführer kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche
vom Rat der Geschäftsführer vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur
Verfügung stehen. Der ausschüttbare Betrag wird gegebenenfalls im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 8 und
des Artikels 28.6 verteilt und darf nicht die Summe der seit dem Ende des vergangenen Geschäftsjahres angefallenen
Gewinne, gegebenenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne und ausschüttbare Rücklagen, beziehungsweise vermindert
durch vorgetragene Verluste und Summen, die einer Rücklage zugeführt werden, welche nach dem Gesetz von 1915 oder
dieser Satzung nicht ausgeschüttet werden darf, übersteigen.
29.2 Das Agio, andere Kapitalreserven und andere ausschüttbare Rücklagen können im Einklang mit den Bestimmungen
des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.
G. Liquidation
Art. 30. Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Liqui-
dation durch einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden,
die über die Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit
149806
L
U X E M B O U R G
nichts anderes bestimmt wird, haben die Liquidatoren die weitestgehenden Befugnisse für die Verwertung der Vermö-
genswerte und die Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
H. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht
Art. 31 Anwendbares Recht.
31.1 Sämtliche in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten unterliegen den Bestimmungen des Gesetzes von
1915 und jeder Gesellschaftervereinbarung, die die Gesellschafter mitunter mit der Gesellschaft eingehen und durch die
bestimmte Bestimmungen dieser Satzung ergänzt werden könnten. Sollte ein Artikel dieser Satzung mit den Bestimmungen
einer Gesellschaftervereinbarung in Widerspruch stehen, so ist die Gesellschaftervereinbarung zwischen den Parteien,
soweit nach luxemburgischem Recht zulässig, maßgebend.
31.2 Diese Satzung wurde auf Englisch verfasst, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; im Falle von Abweichungen
zwischen der englischen und der deutschen Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.“
5. Verschiedenes.
Nach ordnungsgemäßer Prüfung jedes Tagesordnungspunkts fasst die Gesellschafterversammlung einstimmig die fol-
genden Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung nimmt Aismare, vorbenannt, als neuen Gesellschafter der Gesellschaft an.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt, das Gesellschaftskapital der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von
zweiundzwanzigtausendsiebenhundertfünfzig Euro (EUR 22.750) um einen Betrag von achthunderteinundzwanzig Euro
(EUR 821) auf einen Betrag von dreiundzwanzigtausendfünfhunderteinundsiebzig Euro (EUR 23.571) durch die Ausgabe
von achthunderteinundzwanzig (821) Anteilen der Serie C mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1), zu erhöhen.
<i>Zeichnungi>
Die achthunderteinundzwanzig (821) Anteile der Serie C wurden von Aismare, vorbenannt, hier vertreten wie vor-
erwähnt, zu einem Preis von achthunderteinundzwanzig Euro (EUR 821) gezeichnet.
<i>Zahlungi>
Die von Aismare, vorbenannt, gezeichneten achthunderteinundzwanzig (821) Anteile der Serie C wurden vollständig
eingezahlt durch eine Bareinlage in Höhe von achthunderteinundzwanzig Euro (EUR 821).
Die Summe von achthunderteinundzwanzig Euro (EUR 821) steht der Gesellschaft ab sofort zur freien Verfügung, so
wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde.
Die Einlage in Höhe von achthunderteinundzwanzig Euro (EUR 821) wird vollständig dem Gesellschaftskapital zuge-
führt.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt, Artikel fünf Punkt eins (5.1) der Satzung der Gesellschaft zu ändern, welcher
nunmehr wie folgt lautet:
„ Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt dreiundzwanzigtausendfünfhunderteinundsiebzig Euro (EUR
23.571,00), bestehend aus
5.1.1 zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteilen mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1) (die
„Stammanteile”),
5.1.2 achttausendsechshundertfünfundzwanzig (8.625) Anteilen der Serie A mit einem Nominalwert von je einem Euro
(EUR 1) (die „Anteile der Serie A”),
5.1.3 siebenhundertsechsundachtzig (786) Anteilen der Serie B mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1)
(die „Anteile der Serie B”), und
5.1.4 eintausendsechshundertsechzig (1.660) Anteilen der Serie C mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR
1) (die „Anteile der Serie C”, wobei die Anteile der Serie A, die Anteile der Serie B und die Anteile der Serie C im
Folgenden auch als „Vorzugsanteile“ bezeichnet werden).
Die mit den Anteilen verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es wird in dieser Satzung oder
durch das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.“
<i>Vierter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt, unter anderem infolge des Vorstehenden, einstimmig die gänzliche Neu-
fassung der Satzung der Gesellschaft, welche nunmehr wie in der Tagesordnung der vorliegenden Urkunde dargestellt
lautet.
149807
L
U X E M B O U R G
Da die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung geschlossen.
<i>Kosten und Auslageni>
Die Kosten, Auslagen, Honorare und Gebühren jeglicher Art, die von der Gesellschaft zu tragen sind, werden auf
ungefähr EUR 2.500,- geschätzt.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg am eingangs erwähnten Datum.
Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache beherrscht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende
Urkunde auf Verlangen der erschienenen Parteien auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung;
auf Verlangen besagter erschienener Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen
Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.
Die vorstehende Urkunde ist der Bevollmächtigten der erschienenen Parteien, welche dem Notar mit Namen, Vorn-
amen und Wohnsitz bekannt ist, verlesen und vom Notar gemeinsam mit dieser Bevollmächtigten unterzeichnet worden.
Gezeichnet: A. VAN DER WIELEN und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 18 juillet 2014. Relation: LAC/2014/33899. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri>
(signé): I. THILL.
- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - Der Gesellschaft auf Begehr erteilt.
Luxemburg, den 16. September 2014.
Référence de publication: 2014145240/1157.
(140164500) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2014.
Lindab S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9230 Diekirch, route d'Ettelbruck.
R.C.S. Luxembourg B 91.774.
<i>Extrait des résolutions de la réunion du conseil d'administration datée du 25 Août 2014i>
Il résulte des décisions prises par le conseil d'administration de la société lors de sa réunion en date du 25.08.2014:
- Acceptation de la révocation de Carl Gustav NILSSON comme administrateur
- Acceptation de la nomination de Fredrik LIEDHOLM comme administrateur (domicilié à Matthias Gülichs gata 9,
S-25433 Helsinborg)
Son mandat est valable jusqu'à la prochaine assemblée générale qui aura lieu en 2015.
Hans BERGER / Romain FUSENIG.
Référence de publication: 2014146220/14.
(140166190) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2014.
Treveria Seventeen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 124.955.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions écrites prises par l'associé unique de la Société en date du 19 septembre 2014 que:
- Les démissions de Monsieur Luc GERONDAL, et de Monsieur Olivier LIEGEOIS, gérants de la Société, avec effet au
31 août 2014, ont été acceptées;
- Les personnes suivantes ont été nommées en tant que gérants, avec effet au 31 août 2014 et ce pour une durée
indéterminée:
* (i) Monsieur Jérôme TIBESAR, né le 21 mars 1979 à Messancy, Belgique, résidant professionnellement au 16, avenue
Pasteur L-2310 Luxembourg;
* (ii) Monsieur Bruno BEERNAERTS, né le 4 novembre 1963 à Ixelles, Belgique, résidant au 162, rue de Reckenthal,
L-2410 Strassen;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 septembre 2014.
Référence de publication: 2014146428/20.
(140166737) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2014.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
149808
Augentius Luxembourg HoldCo S.A.
Augentius Luxembourg S.A.
Borotra S.A.
Brightpoint (Luxembourg) Sàrl
Brookridge 1
CGE Investments (No. 1) S.à r.l.
City Living Group S.à r.l.
CORNÈR BANQUE (Luxembourg) S.A.
Deutsche Zinshaus Lux S.à r.l.
Dutch Venture Initiative S.A. SICAR
Fell-Systemhaus-Lux S.à r.l.
Hasten Property Holdings S.à r.l.
Infodatainvest S.A.
Intermeat Services S.A.
INVESCO Real Estate Management S.à r.l.
Investissement International Immobilier SA
JAN.CO S.A.
K13 Holding S.A.
La Coccinella S.à r.l.
Letzebuerger Theater a.s.b.l.
Limoreal S.A.
Lindab S.A.
Luxdynamic S.A.
Lux Snacks S.à r.l.
Metaform S.à r.l.
Meubles Kandel s.à.r.l.
NII International Holdings S.à r.l.
NNS Holding S.à r.l.
Partners Group European Mezzanine 2008 S.C.A., SICAR
Rowan Finanz S.à r.l.
Salon La Brosse S.à r.l.
Sama-International S.A.
Schop Investissements S.A.
Simres Real Estate Sàrl
SJ Investment S.A.
Smith & Nephew International S.A.
Sofibru S.A.
Stahr Pierre S.à r.l.
Telenet International Finance S.à r.l.
Tiger Tail Investments S.A.
Tramet s.à r.l.
Treveria Seventeen S.à r.l.
Triton Debt Opportunities S.C.A.
T.Rowe Price Funds Series II Sicav
T. Rowe Price (Luxembourg) Management Sàrl
Van Egmond
VEREF I Invest Co 1 S.à r.l.
Violet Investments S.à r.l.
Watera International
Zencap Global S.à r.l.