This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 3065
22 octobre 2014
SOMMAIRE
Bluere Investment Limited, S.à r.l. . . . . . .
147086
Capula ESS Lux 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
147115
Censi SP S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147117
Crosslink Investment Consulting S.A. . . . .
147074
Fibalux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147114
France Property Holdco IV S.à r.l. . . . . . . .
147074
France Property Holdco S.à r.l. . . . . . . . . . .
147074
Gallina Invest S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147079
GaveKal Multi-Strategy Fund SIF SICAV
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147080
Glenda 1980 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147079
Glenmoore S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147077
Guardian Segur S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147078
Harbour HoldCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
147077
Helarb Investments Partners (SCA) SI-
CAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147078
Honeywell Holding Europe Limited LLC
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147081
Huggy-Store Hoscheid Dickt Sàrl . . . . . . . .
147077
LDV Management III S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
147079
LDV Management S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
147079
Lewington S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147105
Lux-Fiduciaire S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147080
Mainoria SICAV - SIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147078
Mapitop S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147084
Neightilus S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147087
Norwich S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147093
Olympia Management S.à r.l. . . . . . . . . . . .
147076
Opus Securities S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147077
Oystercatcher Luxco 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . .
147074
Panlip S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147079
Pergam Properties 2 S.C.A. . . . . . . . . . . . . .
147080
Pergam Properties 2 S.C.A. . . . . . . . . . . . . .
147080
Petroleum Marine Services . . . . . . . . . . . . .
147078
PLF Licensing S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147081
PO Invest 1 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147081
Portofino Properties . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147076
Property S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147081
Ravago S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147083
Saint-Georges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147118
Secure S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147075
Sinequanon Health Care SA . . . . . . . . . . . .
147075
Société Immobilière auf dem Butterbrill
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147082
Société Luxembourgeoise de Transports
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147074
Soparlux International S.A. . . . . . . . . . . . . .
147082
Stark PSM Technology S.à r.l. . . . . . . . . . . .
147090
STEPEC PROMOTION Luxembourg
S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147082
Tescara S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147083
Timken Luxembourg Holdings Sàrl . . . . . .
147082
Transport Da Conceicao Martins S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147083
United Bargain Société de Participations
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147076
Universal Premium Trading . . . . . . . . . . . . .
147075
V.D.T.I. S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147083
Zimmer & Partners S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
147076
147073
L
U X E M B O U R G
France Property Holdco IV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 139.575.
Les comptes abrégés au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
À Luxembourg, le 16 septembre 2014.
Référence de publication: 2014144087/10.
(140164174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2014.
France Property Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 131.577.
Les comptes abrégés au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
À Luxembourg, le 16 septembre 2014.
Référence de publication: 2014144088/10.
(140164176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2014.
Société Luxembourgeoise de Transports S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 7-9, rue d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 62.848.
L'adresse de M. Bertrand TARDY, Administrateur et Administrateur-Délégué est la suivante: 27, avenue de la Gare,
L-1611 Luxembourg.
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2014144456/11.
(140163759) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2014.
Oystercatcher Luxco 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue John F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 130.818.
Les comptes annuels au 31 Mars 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Antoine Clauzel
<i>Géranti>
Référence de publication: 2014145009/11.
(140164648) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2014.
Crosslink Investment Consulting S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 56.765.
Suite à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société, qui s'est tenue le 14 mai 2014, il a été décidé:
- de renouveler le mandat de Mme. Mariia Nikolenko, en tant qu'administrateur de la Société avec effet immédiat et
ce pour une période jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 mai 2014.
Signature.
Référence de publication: 2014144021/12.
(140164068) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2014.
147074
L
U X E M B O U R G
Secure S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 157.539.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014143735/9.
(140163425) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2014.
Universal Premium Trading, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 158.791.
<i>Extrait de résolution du conseil de gérance 2 juillet 2014i>
Le conseil de gérance accepte la démission de Monsieur Vincent de Rycke.
Le conseil de gérance décide de coopter Monsieur Bismark Badilla, résidant professionnellement à Bahnhostrasse 23,
CH-6300 Zug, Suisse, en tant que gérant jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 septembre 2014.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2014143789/14.
(140162680) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2014.
Sinequanon Health Care SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.
R.C.S. Luxembourg B 136.999.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement à Luxembourg le 25 août 2014i>
L'Assemblée Générale a pris les résolutions suivantes:
- L'Assemblée Générale accepte le non-renouvellement de:
* M. Arnaud Dartois , né le 5 Juillet 1978, à Angoulême (France), résidant au 11, Rue de Sèvres, F75006 Paris, en tant
qu'administrateur B, avec effet au 25 août 2014.
- L'Assemblée Générale accepte la nomination de:
* Mme Brigitte Caille,née le 28 Décembre 1953 à Alger (Algérie), résidant au 36, rue de la Ronce, F-92410 Ville d'Avray
(France), en tant qu'administrateur B, avec effet au 25 août 2014.
- L'Assemblée Générale décide de renouveler les mandats de:
* M. Daniel Caille, né le 6 Avril 1951, à Lyon (France), résidant au 36 me de la Ronce, F-92410 Ville d'Arvay, en tant
qu'administrateur A et Président.
* M. Guillaume Raoux, né le 14 Février 1970, à Bagnols/Ceze (France), résidant au 41, Rue Ernest Renan, F-92310
Sèvres, en tant qu'administrateur B.
aux fonctions d'administrateurs.
* Kohnen & Associés S à.r.l. , ayant son siège social 62, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, enregistrée au
registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 114.190,
à la fonction de Commissaire aux Comptes.
Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice se
clôturant le 31 Décembre 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 septembre 2014.
<i>Pour Sinequanon Health Care S.A.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2014143749/31.
(140162890) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2014.
147075
L
U X E M B O U R G
Portofino Properties, Société Anonyme.
Siège social: L-1232 Howald, 6, rue Ernest Beres.
R.C.S. Luxembourg B 50.133.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014143686/10.
(140162963) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2014.
Olympia Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2347 Luxembourg, 1, rue du Potager.
R.C.S. Luxembourg B 169.232.
Les comptes annuels arrêtés au 31/12/13 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Olympia Management S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Signature
Référence de publication: 2014144338/13.
(140163590) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2014.
Zimmer & Partners S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 151.507.
<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration tenu en date du 11 septembre 2014i>
Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 11 septembre 2014 que:
- Le siège social de la société est transféré du 3-7 rue Schiller L-2519 Luxembourg au 50 rue Charles Martel L-2134
Luxembourg, avec effet au 1
er
septembre 2014.
- L'administrateur M. Claude ZIMMER est domicilié professionnellement au 50 rue Charles Martel L-2134 Luxembourg
et ce, avec effet au 1
er
septembre 2014.
Extrait sincère et conforme
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2014143820/15.
(140163372) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2014.
United Bargain Société de Participations S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 13.035.
Par décision du Conseil d'Administration tenu en date du 10 septembre 2014, Monsieur Stanislas BUNETEL, domicilié
professionnellement au 42, Rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, a été coopté au Conseil d'Administration en rempla-
cement de Monsieur Guy BAUMANN, démissionnaire.
Son mandat s'achèvera avec ceux des autres Administrateurs à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2017.
Luxembourg, le 15 septembre 2014.
<i>Pour: UNITED BARGAIN SOCIETE DE PARTICIPATIONS S.A.
i>Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Référence de publication: 2014143791/16.
(140163376) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2014.
147076
L
U X E M B O U R G
Glenmoore S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 123.723.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014144118/9.
(140164289) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2014.
Huggy-Store Hoscheid Dickt Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9835 Hoscheid-Dickt, 1, Haaptstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 95.150.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour HUGGY-STORE HOSCHEID-DICKT SARL
i>Société à responsabilité limitée
FIDUCIAIRE DES P.M.E. SA
Référence de publication: 2014144168/12.
(140163793) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2014.
Opus Securities S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 114.001.
<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration de la société en date du 10 septembre 2014i>
Le conseil d'administration de la Société décide de renouveler le mandat de Deloitte Audit, avec siège social au 560,
rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, enregistré sous le numéro B 67 895 au Registre de Commerce et des Sociétés du
Luxembourg, en tant que réviseur externe de la Société pour l'audit des comptes se clôturant au 31 décembre 2014.
A Luxembourg, le 15 septembre 2014.
Pour extrait conforme
Signatures
<i>L'agent-domiciliatairei>
Référence de publication: 2014144327/15.
(140163697) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2014.
Harbour HoldCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 2C, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 143.938.
EXTRAIT
Les associés de la Société, par résolutions écrites datées du 24 juin 2014, ont décidé de transférer le siège social de
la Société au 2C, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, avec effet au 15 septembre 2014.
Les adresses professionnelles des gérants Heiko Dimmerling, Thomas Sonnenberg, Michiel Kramer et Antonis Tzanetis
ont également changés. Lesdits gérants résident dorénavant professionnellement au 2C, rue Albert Borschette, L-1246
Luxembourg.
Le gérant Mats Eklund a également transféré son adresse professionnelle au 9 South Street, 3
ème
étage, Londres, W1K
2XA, Royaume-Uni.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Harbour HoldCo S.à r.l.i>
Référence de publication: 2014144143/18.
(140164327) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2014.
147077
L
U X E M B O U R G
Guardian Segur S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 168.659.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014144128/10.
(140163698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2014.
Helarb Investments Partners (SCA) SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une
Société d'Investissement en Capital à Risque.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 124.846.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 septembre 2014.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2014144162/12.
(140163623) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2014.
Petroleum Marine Services, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 104.843.
Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Petroleum Marine Services
Société à responsabilité limitée
Signature
Référence de publication: 2014144352/14.
(140164427) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2014.
Mainoria SICAV - SIF, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 1A, rue Pierre d'Aspelt.
R.C.S. Luxembourg B 35.627.
<i>L'Assemblée Générale Ordinaire de Mainoria SICAV-SIF tenue au siège le 27 juin 2014i>
A décidé la nomination, jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2017, des Administrateurs suivants:
Monsieur Charles Kesteloot
19 place Sainte-Gudule
B-1000 Bruxelles
Et
Monsieur Gaëtan van der Bruggen
1A rue Pierre d'Aspelt L-1142
L-1142 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 septembre 2014.
Référence de publication: 2014144280/18.
(140164141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2014.
147078
L
U X E M B O U R G
Gallina Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 157.811.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014144129/10.
(140163956) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2014.
Glenda 1980 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1148 Luxembourg, 12, rue Jean l'Aveugle.
R.C.S. Luxembourg B 174.299.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour GLENDA 1980 S.A.i>
Référence de publication: 2014144131/10.
(140164411) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2014.
LDV Management III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 143.102.
<i>Rectificatif du dépôt référencé sous le numéro L130139961 du 9 août 2013i>
Le bilan rectificatif au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014144233/10.
(140164423) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2014.
LDV Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 96.644.
<i>Rectificatif du dépôt référencé sous le numéro L130146389 du 23 août 2013i>
Le bilan rectificatif au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014144234/10.
(140164451) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2014.
Panlip S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 59.366.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 11 août 2014i>
Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont venus à échéance.
Monsieur Jean-Marie LEGENDRE et les sociétés FMS SERVICES S.A. et S.G.A. SERVICES S.A., sont réélus Adminis-
trateurs pour une nouvelle période de 6 ans.
Monsieur Eric HERREMANS, est réélu Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période de 6 ans
<i>Pour la société
i>PANLIP S.A., SPF
Référence de publication: 2014144360/14.
(140164186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2014.
147079
L
U X E M B O U R G
Lux-Fiduciaire S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.
R.C.S. Luxembourg B 65.819.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014144252/9.
(140164343) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2014.
GaveKal Multi-Strategy Fund SIF SICAV S.A., Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'In-
vestissement Spécialisé.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 157.563.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
GAVEKAL MULTI-STRATEGY FUND SIF SICAV S.A.
Société Anonyme
Référence de publication: 2014144117/12.
(140164222) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2014.
Pergam Properties 2 S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 32-36, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 148.104.
<i>Extrait d'un procès-verbal d'une réunion pour la société qui s'est tenue au siège social de la société en date du 20 mars 2014 ài>
<i>17 heuresi>
MME SOPHIE JILGER (PRÉSIDENT DU CONSEIL DE GERANCE)
MME CLAIRE LAURENT
MR JEAN-BERNARD QUILLON
<i>1. Résolution uniquei>
Le Conseil de Gérance de la Société, à savoir son organe de compétence, Pergam Properties Gp a décidé de transférer
le siège social 32-36 boulevard d'Avranches à Luxembourg (L-1160).
Référence de publication: 2014144371/15.
(140163992) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2014.
Pergam Properties 2 S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 32-36, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 148.104.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires de la société tenue le 25 juin 2014 à 15.00i>
<i>heures au siège social de la société.i>
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée générale constate et accepte la démission de Certifica Luxembourg S.à r.l. en sa qualité de membre du
conseil de surveillance et nomme en remplacement Monsieur Manuel Barth, demeurant professionnellement au 49/51
avenue George V à Paris (F-75008), pour une durée maximum de 5 ans, mandat venant à expiration lors de la tenue de
l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de l'année 2019.
<i>Cinquième résolutioni>
L'Assemblée décide de procéder au renouvellement du mandat de réviseur d'entreprises agréé de PriceWaterhou-
seCoopers S.à r.l., ayant son siège social à L-1014 Luxembourg, 400 route d'Esch, enregistrée sous le numéro B65 477
au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, et ce pour une durée d'un an.
Référence de publication: 2014144370/18.
(140163992) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2014.
147080
L
U X E M B O U R G
PLF Licensing S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 158.038.
Complète et remplace le dépôt L140134386 du 30/07/2014
Le bilan pour la période du 1
er
janvier au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014144373/12.
(140164321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2014.
Property S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 153.461.
En date du 30 juin 2014, Monsieur Valentino Capurso, titulaire d'un Master en comptabilité, contrôle audit, avec adresse
professionnelle à L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire a été nommé comme commissaire en remplacement
de Maître Pierre Berna démissionnaire.
Son mandat prendra fin avec l'assemblée générale de 2019.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Property SA
Référence de publication: 2014144381/13.
(140163587) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2014.
Honeywell Holding Europe Limited LLC, Société en Commandite simple.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 159.118.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions circulaires des associés de la Société prises en date du 8 septembre 2014 que le siège social
de la Société a été transféré du 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg au 43, boulevard Prince Henri, L-1724
Luxembourg, avec effet au 8 septembre 2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
Honeywell Holding Europe Limited LLC S.C.S
Référence de publication: 2014142828/14.
(140162439) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2014.
PO Invest 1 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1136 Luxembourg, 1, place d'Armes.
R.C.S. Luxembourg B 115.493.
<i>Extrait des résolutions de l'assemblée générale des actionnaires prises en date du 20 Mai 2014i>
A été nommée réviseur d'entreprises la société HRT Révision SA, dont le siège social se situe au 163 rue du Kiem,
L-8030 Strassen, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 051.238, jusqu'à
l'Assemblée Générale prévue en 2015.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour PO Invest 1 S.A.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2014144374/15.
(140163967) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2014.
147081
L
U X E M B O U R G
Société Immobilière auf dem Butterbrill, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3895 Foetz, rue de l'Industrie.
R.C.S. Luxembourg B 175.170.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Windhof, le 12/09/2014.
Référence de publication: 2014143053/10.
(140162308) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2014.
Timken Luxembourg Holdings Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 92.503.
Statuts coordonnés, suite à l’assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de rési-
dence à Esch/Alzette, en date du 22 avril 2014 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 22 mai 2014.
Référence de publication: 2014143122/11.
(140162282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2014.
STEPEC PROMOTION Luxembourg S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2562 Luxembourg, 4, place de Strasbourg.
R.C.S. Luxembourg B 86.342.
Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales le 16 juin 2014 que le capital de la société est répartit comme suit:
M. HOLLER CHRISTOPHE
29, VOIE ROMAINE
F-57 460 ETZLING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 parts
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 parts
Luxembourg, le 04 septembre 2014.
<i>Pour la sociétéi>
Référence de publication: 2014143105/14.
(140162321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2014.
Soparlux International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 142.354.
EXTRAIT
Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire de la Société tenue en date du 1
er
septembre 2014 que:
- Les démissions de M. Jean-Michel DESPAUX et M. Olivier LIEGEOIS, administrateurs de la Société ont été acceptées
avec effet immédiat;
- Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs de la Société, avec effet immédiat et ce jusqu'à l'assemblée
générale qui statuera sur les comptes arrêtés au 30 juin 2018:
* (i) Mr. Bruno BEERNAERTS, né le 4 novembre 1963 à Ixelles, Belgique, résidant professionnellement au 16, avenue
Pasteur L-2310 Luxembourg;
* (ii) Mme Jessica DA SILVA, née le 21 juillet 1981 à Mont Saint Martin, France, résidant professionnellement au 16,
avenue Pasteur L-2310 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 septembre 2014.
Référence de publication: 2014143097/19.
(140162530) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2014.
147082
L
U X E M B O U R G
V.D.T.I. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8352 Dahlem, 37, rue des Trois Cantons.
R.C.S. Luxembourg B 48.956.
Le bilan au 31.12.2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014143134/9.
(140162327) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2014.
Tescara S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 73.676.
Les comptes au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
TESCARA S.A.
Référence de publication: 2014143117/10.
(140162229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2014.
Ravago S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 16, rue Notre-Dame.
R.C.S. Luxembourg B 88.948.
<i>Extract of the resolutions of the circular Board of Directorsi>
According to the article 64 (2) of the law dated August 10
th
, 1915 relating to commercial companies, the Directors
decide to appoint Ravago Management S.à R.L., represented by Mrs. Gunhilde VAN GORP, Permanent Representative,
as Chairman of the Board. The company acts as Chairman for the whole period of his mandate.
Luxembourg, the 22/08/2014 .
For true copy
RAVAGO S.A.
Benoît PARMENTIER / Paul DEPUYDT
<i>Director / Directori>
<i>Extrait des résolutions du Conseil d'Administration tenu par voie circulairei>
Les Administrateurs élisent en leur sein, conformément aux dispositions de l'article 64 (2) de la loi modifiée du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, un Président en la société Ravago Management S.à R.L., représentée par Mme
Gunhilde VAN GORP, Représentant Permanent. La société assumera cette fonction pendant la durée de son mandat.
Fait à Luxembourg, le 22/08/2014.
Certifié sincère et conforme
RAVAGO S.A.
Benoît PARMENTIER / Paul DEPUYDT
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2014143027/25.
(140162315) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2014.
Transport Da Conceicao Martins S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3672 Kayl, 82, rue de Tétange.
R.C.S. Luxembourg B 123.852.
Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014143127/10.
(140161968) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2014.
147083
L
U X E M B O U R G
Mapitop S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5751 Frisange, 38, Robert Schuman-Stross.
R.C.S. Luxembourg B 190.087.
STATUTS
L'an deux mille quatorze.
Le cinq septembre.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).
ONT COMPARU:
1.- Madame Evita JORDAO, gérante de société, née le 26 juillet 1977 à Bastogne (Belgique), demeurant à L-5751
Frisange, 38, Robert Schuman-Strooss.
2.- Madame Christelle KOEUNE, assistante administrative, née le 18 mai 1972 à Bastogne (Belgique), demeurant à
B-6690 Vielsalm, Hébronval n° 27.
Lesquelles comparantes sont ici représentées par Peggy Simon, employée privée, demeurant professionnellement à
Echternach, 9, Rabatt, en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées en date du 13 août 2014,
lesquelles procurations, après avoir été signées "ne varietur" par la mandataire des comparantes et le notaire instru-
mentant, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.
Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont déclaré former par les présentes une société à res-
ponsabilité limitée, régie par la loi afférente et par les présents statuts.
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et les propriétaires
de parts qui pourront l’être dans la suite, une société à responsabilité limitée régie par la loi du 10 août 1915, la loi du
18 septembre 1933 et par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet la création et la gestion d’un site internet, la consultation en télécommunication,
l’implémentation de services de télécommunication, l’élaboration de services multimédia, toutes activités qui se rappor-
tent directement ou indirectement à son objet, ainsi que toutes opérations commerciales, financières, mobilières et
immobilières.
La société pourra développer son business modèle par le biais de la franchise.
La société est autorisée à contracter des emprunts pour son propre compte et à accorder tous cautionnements ou
garanties.
La société peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion ou par tout autre moyen à des sociétés ou des entreprises
ayant en tout ou partie un objet similaire, connexe ou complémentaire au sien, ou apte à en promouvoir ou faciliter la
réalisation et ce tant au Grand-Duché qu'à l’étranger.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée sauf le cas de dissolution.
Art. 4. La société prend la dénomination de «MAPITOP S.à r.l.».
Art. 5. Le siège social est établi à Frisange.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger en vertu d'un consen-
tement des associés.
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500.-), représenté par
mille (1.000) parts sociales sans désignation de valeur nominale.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l’article cent quatre-vingt-
dix-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l’actif social
ainsi que des bénéfices.
Art. 9. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l’agrément donné en assemblée
générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément des
propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.
Dans le cas de l’alinéa 2 le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des héritiers réser-
vataires, soit au conjoint survivant et, pour autant que les statuts le prévoient, aux autres héritiers légaux.
Les héritiers ou les bénéficiaires d'institutions testamentaires ou contractuelles qui n'ont pas été agréés et qui n'ont
pas trouvé un cessionnaire réunissant les conditions requises, peuvent provoquer la dissolution anticipée de la société,
trois mois après une mise en demeure signifiée aux gérants par exploit d'huissier et notifiée aux associés par pli recom-
mandé à la poste.
147084
L
U X E M B O U R G
Toutefois, pendant le dit délai de trois mois, les parts sociales du défunt peuvent être acquises, soit par les associés,
sous réserve de la prescription de la dernière phrase de l’art. 199 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
et ses modifications ultérieures, soit par un tiers agréé par eux, soit par la société elle-même, lorsqu'elle remplit les
conditions exigées pour l’acquisition par une société de ses propres titres.
Le prix de rachat des parts sociales se calcule sur la base du bilan moyen des trois dernières années et, si la société
ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.
S'il n'a pas été distribué de bénéfice, ou s'il n'intervient pas d'accord sur l’application des bases de rachat indiquées par
l’alinéa précédent, le prix sera fixé, en cas de désaccord, par les tribunaux.
L'exercice des droits afférents aux parts sociales du défunt est suspendu jusqu'à ce que le transfert de ces droits soit
opposable à la société.
Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seings privés.
Elles ne sont opposables à la société et aux tiers qu'après qu'elles ont été signifiées à la société ou acceptées par elle
dans un acte notarié conformément à l’art. 1690 du Code civil.
Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit faire apposer
des scellés sur les biens et documents de la société.
Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l’assemblée
des associés.
Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration, de gestion et de disposition
intéressant la société, à condition qu'ils rentrent dans l’objet social.
En cas de pluralité de gérants, l’assemblée générale fixe les attributions et pouvoirs des différents gérants.
La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature du ou des gérants agissant dans la limite
de l’étendue de sa fonction telle qu'elle résulte de l’acte de nomination.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.
Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent,
dans les formes prévues par l’article 193 de la loi sur les sociétés commerciales.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre.
Art. 16. Chaque année, le trente-et-un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société, le bilan et le compte de profits et pertes, le tout
conformément à l’article 197 de la loi du 18 septembre 1933.
Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.
Art. 18. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et des amor-
tissements constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-
ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition des associés.
Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.
Art. 20. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions prévues par l’article cent quatre-vingt-trois des lois sur les
sociétés (loi du dix-huit septembre mil neuf cent trente-trois) se trouvent remplies.
<i>Souscription et libération du capital sociali>
Les mille (1.000) parts sociales ont été souscrites comme suit:
1.- Madame Evita JORDAO, prénommée, neuf cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
900
2.- Madame Christelle KOEUNE, prénommée, cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
Total: mille parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000
147085
L
U X E M B O U R G
Toutes ces parts ont été immédiatement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de DOUZE
MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500.-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été
justifié au notaire qui le constate expressément.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2014.
<i>Evaluationi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille Euros (€ 1.000.-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt les associées, représentées comme dit ci-avant, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunies
en assemblée générale et à l’unanimité des voix, elles ont pris les résolutions suivantes.
1.- Est nommée gérante de la société pour une durée indéterminée:
Madame Evita JORDAO, gérante de société, née le 26 juillet 1977 à Bastogne (Belgique), demeurant à L-5751 Frisange,
38, Robert Schuman-Strooss.
2.- La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de la gérante.
3.- Le siège social de la société est établi à L-5751 Frisange, 38, Robert Schuman-Strooss.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparantes au fait qu'avant toute activité commerciale de la société
présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparantes.
DONT ACTE, fait et passé à Echternach, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparantes, connue du notaire instrumentant par
nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. SIMON, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 05 septembre 2014. Relation: ECH/2014/1618. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): J.-M. MINY.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Echternach, le 12 septembre 2014.
Référence de publication: 2014142937/133.
(140162055) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2014.
Bluere Investment Limited, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 172.022.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 12 août 2014i>
1. M. Anthony AUDIA a démissionné de son mandat de gérant B.
2. M. Joel CARDENAS SAN MARTIN, administrateur de sociétés, né à Bilbao (Espagne), le 3 mars 1978, demeurant
professionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommé comme gérant B pour une durée
indéterminée.
3. Le siège social a été transféré de L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte à L-2453 Luxem-
bourg, 6, rue Eugène Ruppert.
Veuillez prendre note que l'adresse professionnelle de Mme Valérie PECHON, gérante B, se situe désormais à L-2453
Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
Luxembourg, le 18 septembre 2014.
Pour extrait et avis sincères et conformes
<i>Pour Bluere Investment Limited, S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.
Référence de publication: 2014145357/20.
(140165429) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2014.
147086
L
U X E M B O U R G
Neightilus S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 129.285.
In the year two thousand and fourteen, the fifth day of September, before Me Henri BECK, notary residing in Echter-
nach, Grand Duchy of Luxembourg,
was held
an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of Neightilus S.à r.l., a Luxembourg private limited
liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 20, Rue de la Poste, L-2346 Luxembourg,
registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under the number B 129.285 and having a share
capital of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) (the Company). The Company was incorporated pursuant
to a deed enacted by Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg on 4 June
2007 published on 9 August 2007 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, under number 1682, page
80693. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended for the last time pursuant to a deed
of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg on 6 August 2007 published on
11 October 2007 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, under number 2280, page 109420.
THERE APPEARED:
Shepherd Investments International Ltd, a limited company incorporated under the laws of the British Virgin Islands,
having its registered office at Craigmuir Chambers, Road Town, BVI - Tortola, British Virgin Islands and registered with
the British Virgin Islands chamber of commerce under number 151728 and holding 8,250 shares of the Company;
Stark Investments Limited Partnership., a limited partnership incorporated under the laws of the United States of
America, having its registered office at 10556, Port Washington Road, USA - 53092 Mequon, Wisconsin, and registered
with the chamber of commerce of Wisconsin under number 5046020 and holding 2,875 shares of the Company;
Stark Global Opportunities Fund Ltd, a limited company incorporated under the laws of the British Virgin Islands,
having its registered office at Craigmuir Chambers, Road Town, BVI - Tortola, British Virgin Islands and registered with
the British Virgin Islands chamber of commerce under number 1048547 and holding 1,000 shares of the Company; and
Stark Global Opportunities Fund L.P., a limited partnership incorporated under the laws of the United States of Ame-
rica, having its registered office at 2711, Centerville Road, Suite 400, USA - 19808 Wilmington, Delaware and registered
with the chamber of commerce of Delaware under number 5011410 and holding 375 shares of the Company;
all together referred to as the Shareholders,
all hereby represented by Pedro Reis da Silva, lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of powers of
attorney given under private seal.
Said powers of attorney, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing
parties and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the regis-
tration authorities.
The Shareholders, represented as stated above, have requested the undersigned notary to record the following:
I. that the Shareholders hold all the shares in the share capital of the Company;
II. that the Shareholders wish to proceed with the dissolution of the Company and to put it into liquidation;
III. that the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. waiver of convening notices;
2. dissolution of the Company and decision to voluntarily put the Company into liquidation (liquidation volontaire);
3. appointment of Stark Entity Services LLC, as liquidator (liquidateur) in relation to the voluntary liquidation of the
Company (the Liquidator);
4. determination of the powers and duties of the Liquidator and determination of the liquidation procedure of the
Company;
5. decision to instruct the Liquidator to realise, on the best possible terms and for the best possible consideration, all
the assets of the Company and to pay all the debts of the Company;
6. decision that the Liquidator will be entitled to a specific compensation; and
7. miscellaneous.
IV. After having carefully considered the above, the Shareholders have taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Shareholders declare that they have full knowledge of the items on the agenda and waive the requirement for
convocations.
147087
L
U X E M B O U R G
<i>Second resolutioni>
The Shareholders resolve to dissolve and to voluntary put the Company into liquidation (liquidation volontaire).
<i>Third resolutioni>
The Shareholders resolve to appoint Stark Entity Services LLC, a limited liability company incorporated under the laws
of Wisconsin, United-States of America, having its registered office at 3600 South Lake Drive, St. Francis, Wisconsin,
53235 United-States of America, registered with the Wisconsin Department of Financial Institutions under number
S097526, as Liquidator of the Company. The Liquidator is empowered to do everything which is required for the liqui-
dation of the Company and the disposal of the assets of the Company under his sole signature for the performance of
his duties.
<i>Fourth resolutioni>
The Shareholders resolve to confer to the Liquidator the powers set out in articles 144 et seq. of the Luxembourg
law dated August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law).
The Liquidator shall be entitled to pass all deeds and carry out all operations, including those referred to in article 145
of the Law, without the prior authorisation of the Shareholders. The Liquidator may, under his sole responsibility, delegate
some of his powers, for especially defined operations or tasks, to one or several persons or entities.
The Liquidator shall be authorised to make advance payments of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the
Shareholders, in accordance with article 148 of the Law.
<i>Fifth resolutioni>
The Shareholders resolve to instruct the Liquidator to realise, on the best possible terms and for the best possible
consideration, all the assets of the Company and to pay all the debts of the Company.
<i>Sixth resolutioni>
The Shareholders resolve that the Liquidator will be entitled to a specific compensation.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxy holder of the appearing parties, the proxyholder of the appearing parties
signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille quatorze, le cinquième jour du mois de septembre, par devant Maître Henri BECK, notaire de résidence
à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg,
s’est tenue
une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) des associés de Neightilus S.à r.l., une société à responsabilité
limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social se situe au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 129.285 et disposant d’un capital social de
douze mille cinq cents euro (EUR 12.500,-) (la Société). La Société a été constituée suivant acte de Maître Martine
Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 4 juin 2007, publié le 9 août
2007 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, sous le numéro 1682, page 80693. Les statuts de la Société
(les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 6 août 2007, publié le 11 octobre 2007 au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, sous le numéro 2280, page 109420.
ONT COMPARU
Sheperd Investments International Ltd., une société à responsabilitée limitée (limited company) constituée selon les
lois des Îles Vierges Britaniques, ayant son siège social situé à Craigmuir Chamber, Road Town, BVI - Tortola, Îles Vierges
Britaniques et immatriculée auprès de la chambre de commerce des Îles Vierges Britaniques, sous le numéro 151728 et
détenant 8.250 parts sociales de la Société;
Stark Investments Limited Partnership., une société en commandite (limited partnership) constituée selon les lois des
Etats-Unis d’Amérique, ayant son siège social situé à 10556, Port Washington Road, USA - 53092 Mequon, Wisconsin,
et immatriculée auprès de la chambre de commerce du Wisconsin sous le numéro 5046020 et détenant 2.875 parts
sociales de la Société;
Stark Global Opportunities Fund Ltd, une société à responsabilitée limitée (limited company) constituée selon les lois
des Îles Vierges Britaniques, ayant son siège social situé à Craigmuir Chamber, Road Town, BVI - Tortola, Îles Vierges
147088
L
U X E M B O U R G
Britaniques et immatriculée auprès de la chambre de commerce des Îles Vierges Britaniques, sous le numéro 1048547 et
détenant 1.000 parts sociales de la Société; et
Stark Global Opportunities Fund L.P., une société en commandite (limited partnership) constituée selon les lois des
Etats-Unis d’Amérique, ayant son siège social situé à 2711, Centerville Road, Suite 400, USA - 19808 Wilmington, Dela-
ware et immatriculée auprès de la chambre de commerce du Delaware sous le numéro 5011410 et détenant 375 parts
sociales de la Société
collectivement désignées les Associés,
tous représentés par Pedro Reis da Silva, Avocat à la Cour, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu de
procurations données sous seing privé.
Lesdites procurations, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour le compte des parties com-
parantes et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte afin d’être soumises avec celui-ci aux formalités
de l’enregistrement.
Les Associés représentés comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. Que les Associés détiennent toutes les parts sociales dans le capital social de la Société;
II. Que les Associés souhaitent procéder à la dissolution anticipée de la Société et à sa mise en liquidation;
III. Que l’ordre du jour de l’Assemblée est libellé de la manière suivante:
1. renonciation aux formalités de convocation;
2. dissolution de la Société et décision de volontairement mettre la Société en liquidation volontaire;
3. nomination de Stark Entity Services LLC, en tant que liquidateur dans le cadre de la liquidation volontaire de la
Société (le Liquidateur);
4. détermination des pouvoirs et de la mission du Liquidateur et détermination de la procédure de liquidation de la
Société;
5. décision de confier au Liquidateur la mission de réaliser, dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions,
tous les actifs de la Société et de payer toutes les dettes de la Société;
6. décision selon laquelle le Liquidateur aura droit à une rétribution spécifique; et
7. Divers.
IV. Après avoir soigneusement examiné ce qui précède les Associés ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les Associés déclarent avoir entière connaissance de l’ordre du jour et renonce aux formalités de convocation.
<i>Deuxième résolutioni>
Les Associés décident de dissoudre et de volontairement mettre la Société en liquidation volontaire.
<i>Troisième résolutioni>
Les Associés décident de nommer Stark Entity Services LLC, une société à responsabilité limitée (limited liability
company) constituée selon les lois du Wisconsin, Etats-Unis d’Amérique, dont le siège social est situé au 3600, South
Lake Drive, St. Francis, Wisconsin 53235, Etats-Unis d’Amérique, et immatriculée auprès du département des institutions
financières (Department of Financial Institutions) sous le numéro S097526 en tant que Liquidateur de la Société. Le
Liquidateur est autorisé à accomplir tout ce qui est nécessaire à la liquidation de la Société et à la réalisation des actifs
de la Société sous sa seule signature pour l’exécution de son mandat.
<i>Quatrième résolutioni>
Les Associés décident d’attribuer au Liquidateur tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi luxem-
bourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi).
Le Liquidateur est autorisé à passer tous les actes et à exécuter toutes les opérations, en ce compris les actes prévus
à l’article 145 de la Loi, sans l’autorisation préalable des Associés. Le Liquidateur pourra déléguer, sous sa seule respon-
sabilité, certains de ses pouvoirs, pour des opérations ou tâches spécifiquement définies, à une ou plusieurs personnes
physiques ou morales.
Le Liquidateur est autorisé à verser des acomptes sur le boni de liquidation aux Associés conformément à l’article 148
de la Loi.
<i>Cinquième résolutioni>
Les Associés décident de confier au Liquidateur la mission de réaliser, dans les meilleurs délais et dans les meilleures
conditions, tous les actifs de la Société et de payer toutes les dettes de la Société.
<i>Sixième résolutioni>
Les Associés décident que le Liquidateur aura droit à une rétribution spécifique.
147089
L
U X E M B O U R G
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur demande des parties comparantes, le présent
acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. A la demande des mêmes parties comparantes et en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, celui-ci a signé le présent acte
avec le notaire.
Signé: P. REIS DA SILVA, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 08 septembre 2014. Relation: ECH/2014/1622. Reçu douze euros 12,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): J.-M. MINY.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Echternach, le 12 septembre 2014.
Référence de publication: 2014142965/174.
(140162274) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2014.
Stark PSM Technology S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 127.862.
In the year two thousand and fourteen, the fifth day of September, before Me Henri BECK, notary residing in Echter-
nach, Grand Duchy of Luxembourg,
was held
an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of Stark PSM Technology S.à r.l., a Luxembourg
private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 20, Rue de la Poste, L-2346
Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under the number B 127.862 and
having a share capital of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) (the Company). The Company was incorpo-
rated pursuant to a deed enacted by Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
on 18 April 2007 published on 3 July 2007 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, under number 1333,
page 63963. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended for the last time pursuant to
a deed of Maître Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg on 3 July 2007
published on 6 October 2007 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, under number 2218, page 106424.
THERE APPEARED:
Shepherd Investments International Ltd, a limited company incorporated under the laws of the British Virgin Islands,
having its registered office at Craigmuir Chambers, Road Town, BVI - Tortola, British Virgin Islands and registered with
the British Virgin Islands chamber of commerce under number 151728 and holding 10,500 shares of the Company; and
Stark Investment Limited Partnership., a limited partnership incorporated under the laws of the United States of
America, having its registered office at 10556, Port Washington Road, USA - 53092 Mequon, Wisconsin, and registered
with the chamber of commerce of Wisconsin under number 5046020 and holding 2,000 shares of the Company;
all together referred to as the Shareholders,
all hereby represented by Pedro Reis da Silva, lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of powers of
attorney given under private seal.
Said powers of attorney, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing
parties and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the regis-
tration authorities.
The Shareholders, represented as stated above, have requested the undersigned notary to record the following:
I. that the Shareholders hold all the shares in the share capital of the Company;
II. that the Shareholders wish to proceed with the dissolution of the Company and to put it into liquidation;
III. that the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. waiver of convening notices;
2. dissolution of the Company and decision to voluntarily put the Company into liquidation (liquidation volontaire);
3. appointment of Stark Entity Services LLC, as liquidator (liquidateur) in relation to the voluntary liquidation of the
Company (the Liquidator);
4. determination of the powers and duties of the Liquidator and determination of the liquidation procedure of the
Company;
147090
L
U X E M B O U R G
5. decision to instruct the Liquidator to realise, on the best possible terms and for the best possible consideration, all
the assets of the Company and to pay all the debts of the Company;
6. decision that the Liquidator will be entitled to a specific compensation; and
7. miscellaneous.
IV. After having carefully considered the above, the Shareholders have taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Shareholders declare that they have full knowledge of the items on the agenda and waive the requirement for
convocations.
<i>Second resolutioni>
The Shareholders resolve to dissolve and to voluntary put the Company into liquidation (liquidation volontaire).
<i>Third resolutioni>
The Shareholders resolve to appoint Stark Entity Services LLC, a limited liability company incorporated under the laws
of Wisconsin, United-States of America, having its registered office at 3600 South Lake Drive, St. Francis, Wisconsin,
53235 United-States of America, registered with the Wisconsin Department of Financial Institutions under number
S097526, as Liquidator of the Company. The Liquidator is empowered to do everything which is required for the liqui-
dation of the Company and the disposal of the assets of the Company under his sole signature for the performance of
his duties.
<i>Fourth resolutioni>
The Shareholders resolve to confer to the Liquidator the powers set out in articles 144 et seq. of the Luxembourg
law dated August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law).
The Liquidator shall be entitled to pass all deeds and carry out all operations, including those referred to in article 145
of the Law, without the prior authorisation of the Shareholders. The Liquidator may, under his sole responsibility, delegate
some of his powers, for especially defined operations or tasks, to one or several persons or entities.
The Liquidator shall be authorised to make advance payments of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the
Shareholders, in accordance with article 148 of the Law.
<i>Fifth resolutioni>
The Shareholders resolve to instruct the Liquidator to realise, on the best possible terms and for the best possible
consideration, all the assets of the Company and to pay all the debts of the Company.
<i>Sixth resolutioni>
The Shareholders resolve that the Liquidator will be entitled to a specific compensation.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxy holder of the appearing parties, the proxyholder of the appearing parties
signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille quatorze, le cinquième jour du mois de septembre, par devant Maître Henri BECK, notaire de résidence
à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg,
s’est tenue
une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) des associés de Stark PSM Technology S.à r.l., une société à
responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social se situe au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 127.862 et disposant d’un
capital social de douze mille cinq cents euro (EUR 12.500,-) (la Société). La Société a été constituée suivant acte de Maître
Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 18 avril 2007, publié le
3 juillet 2007 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, sous le numéro 1333, page 63963. Les statuts de la
Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence
à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 3 juillet 2007, publié le 6 octobre 2007 au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, sous le numéro 2218, page 106424.
ONT COMPARU
147091
L
U X E M B O U R G
Sheperd Investments International Ltd., une société à responsabilitée limitée (limited company) constituée selon les
lois des Îles Vierges Britaniques, ayant son siège social situé à Craigmuir Chamber, Road Town, BVI - Tortola, Îles Vierges
Britaniques et immatriculée auprès de la chambre de commerce des Îles Vierges Britaniques, sous le numéro 151728 et
détenant 10.500 parts sociales de la Société; et
Stark Investments Limited Partnership., une société en commandite (limited partnership) constituée selon les lois des
Etats-Unis d’Amérique, ayant son siège social situé à 10556, Port Washington Road, USA - 53092 Mequon, Wisconsin,
et immatriculée auprès de la chambre de commerce du Wisconsin sous le numéro [5046020] et détenant 2.000 parts
sociales de la Société;
collectivement désignées les Associés,
tous représentés par Pedro Reis da Silva, Avocat à la Cour, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu de
procurations données sous seing privé.
Lesdites procurations, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour le compte des parties com-
parantes et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte afin d’être soumises avec celui-ci aux formalités
de l’enregistrement.
Les Associés représentés comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. Que les Associés détiennent toutes les parts sociales dans le capital social de la Société;
II. Que les Associés souhaitent procéder à la dissolution anticipée de la Société et à sa mise en liquidation;
III. Que l’ordre du jour de l’Assemblée est libellé de la manière suivante:
1. renonciation aux formalités de convocation;
2. dissolution de la Société et décision de volontairement mettre la Société en liquidation volontaire;
3. nomination de Stark Entity Services LLC, en tant que liquidateur dans le cadre de la liquidation volontaire de la
Société (le Liquidateur);
4. détermination des pouvoirs et de la mission du Liquidateur et détermination de la procédure de liquidation de la
Société;
5. décision de confier au Liquidateur la mission de réaliser, dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions,
tous les actifs de la Société et de payer toutes les dettes de la Société;
6. décision selon laquelle le Liquidateur aura droit à une rétribution spécifique; et
7. Divers.
IV. Après avoir soigneusement examiné ce qui précède les Associés ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les Associés déclarent avoir entière connaissance de l’ordre du jour et renonce aux formalités de convocation.
<i>Deuxième résolutioni>
Les Associés décident de dissoudre et de volontairement mettre la Société en liquidation volontaire.
<i>Troisième résolutioni>
Les Associés décident de nommer Stark Entity Services LLC, une société à responsabilité limitée (limited liability
company) constituée selon les lois du Wisconsin, Etats-Unis d’Amérique, dont le siège social est situé au 3600, South
Lake Drive, St. Francis, Wisconsin 53235, Etats-Unis d’Amérique, et immatriculée auprès du département des institutions
financières (Department of Financial Institutions) sous le numéro S097526 en tant que Liquidateur de la Société. Le
Liquidateur est autorisé à accomplir tout ce qui est nécessaire à la liquidation de la Société et à la réalisation des actifs
de la Société sous sa seule signature pour l’exécution de son mandat.
<i>Quatrième résolutioni>
Les Associés décident d’attribuer au Liquidateur tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi luxem-
bourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi).
Le Liquidateur est autorisé à passer tous les actes et à exécuter toutes les opérations, en ce compris les actes prévus
à l’article 145 de la Loi, sans l’autorisation préalable des Associés. Le Liquidateur pourra déléguer, sous sa seule respon-
sabilité, certains de ses pouvoirs, pour des opérations ou tâches spécifiquement définies, à une ou plusieurs personnes
physiques ou morales.
Le Liquidateur est autorisé à verser des acomptes sur le boni de liquidation aux Associés conformément à l’article 148
de la Loi.
<i>Cinquième résolutioni>
Les Associés décident de confier au Liquidateur la mission de réaliser, dans les meilleurs délais et dans les meilleures
conditions, tous les actifs de la Société et de payer toutes les dettes de la Société.
147092
L
U X E M B O U R G
<i>Sixième résolutioni>
Les Associés décident que le Liquidateur aura droit à une rétribution spécifique.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur demande des parties comparantes, le présent
acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. A la demande des mêmes parties comparantes et en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, celui-ci a signé le présent acte
avec le notaire.
Signé: P. REIS DA SILVA, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 08 septembre 2014. Relation: ECH/2014/1621. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): J.-M. MINY.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Echternach, le 12 septembre 2014.
Référence de publication: 2014143057/160.
(140162206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2014.
Norwich S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.
R.C.S. Luxembourg B 173.404.
In the year two thousand and fourteen, on the twenty-ninth day of the month of August;
Before the undersigned notary Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg);
THERE APPEARED:
The limited liability company incorporated and existing under the laws of the Federal Republic of Germany “BAGR
Berliner Aluminiumwerk GmbH”, with registered office in D-13407 Berlin, Kopenhagener Straße 59, registered with the
Trade Register of the District Court Berlin (Charlottenburg) under number HRB 62201 B,
here represented by Mr. Christian DOSTERT, employee, residing professionally in L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean
Engling, (the “Proxy-holder”), by virtue of a proxy given under private seal; the said proxy, after having been signed “ne
varietur” by the Proxy-holder and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded
with it.
Such appearing party, represented as said before, declares and requests the notary to act that it is the sole current
corporate unit holder (the “Sole Partner”) of “Norwich S.à r.l.”, a private limited liability company governed by the laws
of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office in L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks, registered with the Trade
and Companies Registry of Luxembourg, section B, under number 173404, (the “Company”),
incorporated pursuant to a deed of the notary Henri BECK, residing in Echternach (Grand Duchy of Luxembourg),
on December 5, 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 61 of January 10, 2013,
and whose articles of association (the “Articles”) have been amended pursuant to a deed of the undersigned notary on
November 14, 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 62 of January 8, 2014.
The Sole Partner, represented as here above stated, asked the notary to enact its statements and resolutions as follows:
<i>Preliminary statementi>
The Sole Partner states that at today's date the following companies have been erroneously registered with the Trade
and Companies Registry of Luxembourg as current partners:
- the limited liability company incorporated and existing under the laws of the Republic of Cyprus “Suntmax Co
Limited”, established and having its registered office in CY-6023 Larnaca, 8, Gregori Afxentiou Avenue, ELPA Livadiotis
Building, Office 405, registered with the Cypriot Department of Registrar of Companies and official Receiver under
number HE 247504, as holder of nine thousand three hundred sixty-two (9,362) corporate units; and
- the limited liability company incorporated and existing under the laws of the British Virgin Islands “Golden Hinde
Group Ltd”, established and having its registered office in Tortola, Road Town, Flemming House, 2
nd
floor, registered
with the Registrar of Corporate Affairs of the British Virgin Islands under number 1555741, as holder of three thousand
one hundred thirty-eight (3,138) corporate units.
The Sole Partner hereby requests the cancellation of these pre-mentioned companies and the deferral of the partners'
situation as at January 20, 2014, namely:
- the company “BAGR Berliner Aluminiumwerk GmbH”, pre-mentioned, as as holder of nine thousand three hundred
sixty-two (9,362) corporate units; and
147093
L
U X E M B O U R G
- the company “Swiss Resources Group AG”, mentioned hereafter, as holder of three thousand one hundred thirty-
eight (3,138) corporate units.
<i>First resolutioni>
The Sole Partner decides:
- to dismiss Mrs. Pascale MITRI YOUNÈS as class A manager and Mr. Alexander EICHNER as class B manager;
- to cancel any category of managers; and
- to confirm, in so far as necessary, Mr. Victor Manuel CARBALLO CORRAL, born in Coruna (Spain), on April 22,
1959, residing in MC-98000 Monaco, 4, Avenue des Guelfes (Principality of Monaco), as henceforth sole manager of the
Company.
<i>Second resolutioni>
It is stated, that pursuant to a corporate unit transfer under private seal dated August 18, 2014, the public limited
company incorporated and existing under the laws of Switzerland “Swiss Resources Group AG”, with registered office
in CH-6301 Zug, Obmoos 4, registered with the Commercial Register of canton Zug under companies identification
number (IDE/UID) CHE-110.206.213, has transferred its three thousand one hundred thirty-eight (3,138) corporate units
held in the Company to the appearing Sole Partner.
<i>Notification - Approvali>
According to article 10 of the Articles and to article 190 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as
amended, the Company,
duly represented by its pre-named manager Mr. Victor Manuel CARBALLO CORRAL,
in his turn here duly represented, by virtue of a, to the deed attached, proxy given under private seal by Mr. Christian
DOSTERT, pre-named, fully accepts this transfer of corporate units and considers it as duly notified to the Company,
according to article 1690 of the amended Luxembourg “Code Civil”.
<i>Third resolutioni>
The Sole Partner decides:
- to amend the statutory power of signature of the managers and to adopt for it the wording as reproduced in article
19 of the hereafter restated Articles; and
- to completely restate the Articles, however without amending its essential elements like the corporate purpose.
The ARTICLES will henceforth have the following wording:
A. Name - Purpose - Duration - Registered office
Art. 1. Name - Legal Form. There exists a private limited company („Gesellschaft mit beschränkter Haftung“) under
the name “Norwich S.à r.l.” (hereinafter the “Company”) governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial
companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association (the “Articles”).
Art. 2. Purpose.
2.1 The object of the Company is the administration of the Company's own assets, the acquisition of participations,
interests and units, in Luxembourg or abroad, in any form whatsoever and the management of such participations, interests
and units. The Company may in particular acquire by subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock,
shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more
generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever.
2.2 The Company may borrow and raise funds in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private
placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds
including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities such as, among others, the providing of loans
and the granting of guarantees or securities in any kind or form, to its subsidiaries or companies in which it has a direct
or indirect interest, even not substantial, or to any company being a direct or indirect corporate unit holder of the
Company or any affiliated company belonging to the same group as the Company (hereafter referred to as the “Affiliated
Companies”). It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the
obligations of its Affiliated Companies. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create secu-
rities over all or over some of its assets.
2.3 Furthermore, the Company may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents and/or other
intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.
2.4 The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose
of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.
2.5 The Company may carry out any commercial and/or financial transactions with respect to direct or indirect in-
vestments in movable and immovable property including but not limited to acquiring, owning, hiring, letting, leasing,
147094
L
U X E M B O U R G
renting, dividing, exhausting, reclaiming, developing, improving, cultivating, building on, selling or otherwise alienating,
mortgaging, pledging or otherwise encumbering movable or immovable property.
2.6 The above description is to be understood in the broadest senses and the above enumeration is not restrictive.
Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of corporate unit
holders adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg (Grand Duchy of Luxem-
bourg).
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of
managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution
of the general meeting of corporate unit holders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of
association.
4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution
of the board of managers.
4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances
or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
traordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwiths-
tanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.
B. Corporate capital - Corporate units
Art. 5. Corporate Capital.
5.1 The corporate capital is set at twelve thousand five hundred Euros (12,500.- EUR), divided into twelve thousand
five hundred (12,500) corporate units with a nominal value of one Euro (1.- EUR) each.
5.2 The Company's capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of corporate unit
holders adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
5.3 The Company may redeem its own corporate units.
Art. 6. Corporate units.
6.1 The Company's capital is divided into corporate units, each of them having the same nominal value.
6.2 The corporate units of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several corporate unit holders, with a maximum of forty (40) corporate unit
holders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of
the corporate unit holders shall not cause the dissolution of the Company.
Art. 7. Register of corporate units - Transfer of corporate units.
7.1 A register of corporate unit holders shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available
for inspection by any corporate unit holder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates
of such registration may be issued upon request and at the expense of the relevant corporate unit holder.
7.2 The Company will recognise only one holder per corporate unit. In case a corporate unit is owned by several
persons, they shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has
the right to suspend the exercise of all rights attached to that corporate unit until such representative has been appointed.
7.3 The corporate units are freely transferable among corporate unit holders.
7.4 Inter vivos, the corporate units may only be transferred to new corporate unit holders subject to the approval of
such transfer given by the corporate unit holders at a majority of three quarters of the corporate capital.
7.5 Any transfer of corporate units shall become effective towards the Company and third parties through the noti-
fication of the transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the
Civil Code.
7.6 In the event of death, the corporate units of the deceased corporate unit holder may only be transferred to new
corporate unit holders subject to the approval of such transfer given by the surviving corporate unit holders at a majority
of three quarters of the corporate capital. Such approval is, however, not required in case the corporate units are
transferred either to parents, descendants or the surviving spouse or any other legal heir of the deceased corporate unit
holder.
147095
L
U X E M B O U R G
C. Decisions of the corporate unit holders
Art. 8. Collective decisions of the corporate unit holders.
8.1 The general meeting of corporate unit holders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by
these articles of association.
8.2 Each corporate unit holder may participate in collective decisions irrespective of the number of corporate units
which he owns.
8.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) corporate unit holders, collective decisions
otherwise conferred on the general meeting of corporate unit holders may be validly taken by means of written resolu-
tions. In such case, each corporate unit holder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly
worded and shall cast his vote in writing.
8.4 In the case of a sole corporate unit holder, such corporate unit holder shall exercise the powers granted to the
general meeting of corporate unit holders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of asso-
ciation. In such case, any reference made herein to the “general meeting of corporate unit holders” shall be construed
as a reference to the sole corporate unit holder, depending on the context and as applicable, and powers conferred upon
the general meeting of corporate unit holders shall be exercised by the sole corporate unit holder.
Art. 9. General meetings of corporate unit holders. In case the Company has more than twenty-five (25) corporate
unit holders, at least one general meeting of corporate unit holders shall be held within six (6) months of the end of each
financial year in Luxembourg at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the
convening notice of such meeting. Other meetings of corporate unit holders may be held at such place and time as may
be specified in the respective convening notices of meeting. If all of the corporate unit holders are present or represented
at a general meeting of corporate unit holders and have waived any convening requirement, the meeting may be held
without prior notice or publication.
Art. 10. Quorum and vote.
10.1 Each corporate unit holder is entitled to as many votes as he holds corporate units.
10.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company's
corporate unit holders are only validly taken in so far as they are adopted by corporate unit holders holding more than
half of the corporate capital. If this majority is not reached in a first meeting or proposed written resolution, the corporate
unit holders may be convened a second time with the same agenda or receive such proposed written resolution a second
time by registered letter, decisions are validly adopted in so far as they are adopted by a majority of the votes validly cast
whichever is the fraction of the corporate capital represented.
Art. 11. Change of nationality. The corporate unit holders may change the nationality of the Company only by unani-
mous consent.
Art. 12. Amendments of the articles of association. Any amendment of the articles of association requires the approval
of (i) a majority of corporate unit holders (ii) representing three quarters of the corporate capital at least.
D. Management
Art. 13. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
13.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers
form a board of managers.
13.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not
expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of
association is to be construed as a reference to the “sole manager”.
13.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any
actions necessary or useful to fulfil the Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the
Law or by these articles of association to the general meeting of corporate unit holders.
Art. 14. Appointment, removal and term of office of managers.
14.1 The manager(s) shall be appointed by the general meeting of corporate unit holders which shall determine their
remuneration and term of office.
14.2 The managers shall be appointed and may be removed from office at any time, with or without cause, by a decision
of the corporate unit holders representing more than half of the Company's corporate capital.
14.3 The general meeting of corporate unit holders may decide to appoint managers of two (2) different classes, being
class A managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the
relevant corporate unit holders resolutions and the managers be identified with respect to the class they belong.
Art. 15. Vacancy in the office of a manager.
15.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or
otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
147096
L
U X E M B O U R G
the replaced manager by the remaining managers until the next meeting of corporate unit holders which shall resolve on
the permanent appointment, in compliance with the applicable legal provisions.
15.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company's sole manager, such vacancy must be filled without undue
delay by the general meeting of corporate unit holders.
Art. 16. Convening meetings of the board of managers.
16.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held
at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.
16.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four (24) hours at
least in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document
being sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location
determined in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.
16.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive
any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of
managers.
Art. 17. Conduct of meetings of the board of managers.
17.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not
need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
17.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any
such meeting.
17.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either
in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.
17.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other
means of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis
and allowing an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a
participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.
17.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or
represented at a meeting of the board of managers.
17.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,
if any, shall not have a casting vote. In the event where the general meeting of corporate unit holders has appointed
different classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers
may only be validly taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager
(which may be represented).
17.7. The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in
writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be
the date of the last signature.
Art. 18. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
18.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by
the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. In the event the general meeting of
corporate unit holders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers), such
minutes shall be signed by one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation).
Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the
chairman, if any, or by any two (2) managers. In the event the general meeting of corporate unit holders has appointed
different classes of managers (namely class A managers and class B managers), such copies or excerpts shall be signed by
one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation).
18.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.
Art. 19. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the
signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers;
in the event the general meeting of corporate unit holders has appointed different classes of managers (namely class A
managers and class B managers), the Company will only be validly bound by the joint signatures of at least one (1) class
A manager and one (1) class B manager (including by way of representation) or (ii) by the joint signatures or the sole
signature of any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the
limits of such delegation.
147097
L
U X E M B O U R G
E. Audit and supervision
Art. 20. Auditor(s).
20.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) corporate unit holders, the operations of the
Company shall be supervised by one or several internal auditors (Rechnungskommissar(e)). The general meeting of cor-
porate unit holders shall appoint the internal auditor(s) and shall determine their term of office.
20.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting
of corporate unit holders.
20.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
20.4 If the corporate unit holders of the Company appoint one or more independent qualified auditors (unabhängige
(r) qualifizierte(r) Wirtschaftsprüfer) in accordance with article 69 of the law of December 19, 2002 regarding the trade
and companies' register and the accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal
auditor(s) is suppressed.
20.5. An independent auditor may only be removed by the general meeting of corporate unit holders with cause or
with its approval.
F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends
Art. 21. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end
on the thirty-first of December of the same year.
Art. 22. Annual accounts and allocation of profits.
22.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of
the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.
22.2. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve.
This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten
per cent (10%) of the corporate capital of the Company.
22.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a corporate unit holder may also be allocated to the legal
reserve if the contributing corporate unit holder agrees with such allocation.
22.4 In case of a corporate capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it
does not exceed ten per cent (10%) of the corporate capital.
22.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of corporate unit holders shall determine
how the remainder of the Company's profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.
22.6 Distributions shall be made to the corporate unit holders in proportion to the number of corporate units they
hold in the Company.
Art. 23. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
23.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared
by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may
not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable
reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles
of association do not allow to be distributed.
23.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the corporate
unit holders subject to the provisions of the Law and these articles of association.
G. Liquidation
Art. 24. Liquidation.
24.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the
liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of corporate unit
holders deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise
provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities
of the Company.
24.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among
the corporate unit holders in proportion to the number of corporate units of the Company held by them.
H. Final clause - Governing law
Art. 25. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance
with the Law.
147098
L
U X E M B O U R G
<i>Costs and expensesi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand three hundred
Euros.
<i>Statementi>
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a German version; on request of the same appearing party and
in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the Proxy-holder of the appearing party, acting as said before, known to the notary
by name, first name and residence, the said Proxyholder has signed with Us the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Fassung des vorangehenden Textes:
Im Jahre zweitausendvierzehn, am neunundzwanzigsten Tag des Monats August;
Vor dem unterzeichnenden Notar Carlo WERSANDT, mit Amtssitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg);
IST ERSCHIENEN:
Die nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland gegründete und bestehende Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung „BAGR Berliner Aluminiumwerk GmbH“, mit Sitz in D-13407 Berlin, Kopenhagener Straße 59, eingetragen beim
Handelsregister des Amtsgerichts Berlin (Charlottenburg) unter der Nummer HRB 62201 B,
hier vertreten durch Herrn Christian DOSTERT, Angestellter, beruflich wohnhaft in L-1466 Luxemburg, 12, rue Jean
Engling, (der „Bevollmächtigte“), auf Grund einer ihm erteilten Vollmacht unter Privatschrift; welche Vollmacht, nach „ne
varietur“ Unterzeichnung durch den Vollmachtnehmer der erschienenen Parteien und den instrumentierenden Notar,
gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt, um mit derselben einregistriert zu werden.
Welche erschienene Partei, vertreten wie hiervor erwähnt, erklärt und den amtierenden Notar ersuchen zu beur-
kunden dass sie die alleinige aktuelle Gesellschafterin (die „Alleingesellschafterin“) der „Norwich S.à r.l.“ ist, eine
Gesellschaft mit beschränkter Haftung geregelt durch die Gesetze des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in L-1417
Luxemburg, 8, rue Dicks, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Num-
mer 173404, (die „Gesellschaft“),
gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Henri BECK, mit dem Amtssitz in Echternach (Großherzogtum
Luxemburg), am 5. Dezember 2012, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 61 vom
10. Januar 2013, und deren Gesellschaftsstatuten (die „Statuten“) abgeändert worden sind gemäß Urkunde aufgenommen
durch den unterzeichneten Notar, am 14. November 2013, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, Nummer 62 vom 8. Januar 2014.
Die Alleingesellschafterin, vertreten wie vorerwähnt, hat den unterzeichnenden Notar gebeten, ihre Erklärungen und
Beschlüsse aufzunehmen wie folgt:
<i>Einleitende Erklärungi>
Die Alleingesellschafterin stellt fest, dass zum heutigen Tag folgende Gesellschaften irrtümlicherweise beim Handels-
und Gesellschaftsregister von Luxemburg als Gesellschafter eingetragen worden sind:
die nach dem Recht der Republik Zypern gegründete und bestehende Gesellschaft mit beschränkter Haftung „Suntmax
Co Limited“, mit Sitz in CY-6023 Larnaca, 8, Gregori Afxentiou Avenue, ELPA Livadiotis Building, Office 405, eingetragen
beim zypriotischem Department of Registrar of Companies and official Receiver unter der Nummer HE 247504, als
Inhaberin von neuntausenddreihundertzweiundsechzig (9.362) Gesellschaftsanteilen; und
die nach dem Recht der britischen Jungferninseln gegründete und bestehende Gesellschaft mit beschränkter Haftung
„Golden Hinde Group Ltd“, mit Sitz in Tortola, Road Town, Flemming House, 2
nd
floor, eingetragen beim Registrar of
Corporate Affairs der britischen Jungferninseln unter der Nummer 1555741, als Inhaberin von dreitausendeinhunder-
tachtunddreißig (3.138) Gesellschaftsanteilen.
Die Alleingesellschafterin ersucht hiermit die Streichung dieser vorgenannten Gesellschaften und die Zurückstellung
der Gesellschaftersituation zum 20. Januar 2014, nämlich:
- die Gesellschaft “BAGR Berliner Aluminiumwerk GmbH”, vorgenannt, als Inhaberin von neuntausenddreihundert-
zweiundsechzig (9.362) Gesellschaftsanteilen; und
- die Gesellschaft “Swiss Resources Group AG”, hiernach genannt, als Inhaberin von dreitausendeinhundertachtundd-
reißig (3.138) Gesellschaftsanteilen.
<i>Erster Beschlussi>
Die Alleingesellschafter beschließt:
147099
L
U X E M B O U R G
- Frau Pascale MITRI YOUNÈS als A Geschäftsführerin und Herrn Alexander EICHNER als B Geschäftsführer abzu-
berufen;
- die Kategorien der Geschäftsführer abzuschaffen; und
- Herrn Victor Manuel CARBALLO CORRAL, geboren in Coruna (Spanien), am 22. April 1959, wohnhaft in MC-98000
Monaco, 4, Avenue des Guelfes (Fürstentum Monaco), im erforderlichen Umfang, als fortan alleiniger Geschäftsführer
der Gesellschaft zu bestätigen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Es wird festgestellt, dass auf Grund einer privatschriftlichen Abtretung von Gesellschaftsanteilen datiert auf den 18.
August 2014, die nach dem Recht der Schweiz gegründete und bestehende Aktiengesellschaft „Swiss Resources Group
AG“, mit Sitz in CH-6301 Zug, Obmoos 4, eingetragen beim Handelsregister des Kantons Zug unter der Unternehmens-
Identifikationsnummer (IDE/UID) CHE-110.206.213, ihre dreitausendeinhundertachtunddreißig (3.138) Gesellschaftsan-
teile welche sie in der Gesellschaft hielt an die Alleingesellschafterin abgetreten hat.
<i>Genehmigung - Zustellungi>
Gemäß Artikel 10 der Statuten und Artikel 190 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften,
wie abgeändert, nimmt die Gesellschaft,
rechtmäßig vertreten durch seinen vorgenannten Geschäftsführer Herr Victor Manuel CARBALLO CORRAL,
hier wiederum rechtmäßig vertreten auf Grund einer privatschriftlichen, der Urkunde beigebogenen Vollmacht, durch
Herrn Christian DOSTERT, vorgenannt,
in vollem Umfang diese Gesellschaftsanteilsabtretung an und betrachtet sie als der Gesellschaft ordnungsgemäß zuge-
stellt, gemäß Artikel 1690 des Luxemburger abgeänderten Zivilgesetzbuches.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Alleingesellschafter beschließt:
- die statutarischen Zeichnungsbefugnis der Geschäftsführer abzuändern und für sie den hiernach in Artikel 19 der
neuverfassten Statuten angegebenen Wortlaut anzunehmen; und.
- die Statuten komplett neu zu verfassen, jedoch ohne Abänderung ihrer wesentlichen Merkmale, wie der Gesell-
schaftszweck.
Die STATUTEN werden fortan folgenden Wortlaut haben:
A. Name - Zweck - Dauer - Sitz
Art. 1. Name - Rechtsform. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Bezeichnung „Norwich
S.à r.l.“ (die “Gesellschaft”), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften
in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung (die „Statuten“) unterliegt.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Der Zweck der Gesellschaft ist die Verwaltung des eigenen Vermögens, die Übernahme von Beteiligungen, Anteilen
und Anteilsscheinen in jeglicher Form in Luxemburg oder im Ausland sowie die Verwaltung dieser Beteiligungen, Anteile
und Anteilsscheine. Die Gesellschaft kann insbesondere durch Zeichnung, Kauf, Tausch oder in sonstiger Weise Aktien,
Anteile und andere Genussscheine, Anleihen, Schuldverschreibungen, Einlagenzertifikate und andere Schuldtitel und ganz
allgemein alle Wertpapiere und Finanzinstrumente erwerben, die von öffentlichen oder privaten Rechtspersonen gleich
welcher Art begeben wurden.
2.2 Die Gesellschaft kann Mittel in jeglicher Form, außer über ein öffentliches Zeichnungsangebot, aufnehmen und
beschaffen. Sie kann - ausschließlich im Wege einer Privatplatzierung - Notes, Anleihen und Schuldverschreibungen sowie
Schuldtitel und/oder Aktienwerte emittieren. Die Gesellschaft kann Mittel, einschließlich der Erlöse von Mittelaufnahmen
und/oder Emissionen von Schuldtiteln, unter anderem die Gewährung von Darlehen, Garantien oder Sicherheiten in
jeglicher Art und Weise, an ihre Tochtergesellschaften oder an Unternehmen ausleihen, an denen sie unmittelbar oder
mittelbar beteiligt ist, auch wenn diese Beteiligung nicht erheblich ist, oder an Gesellschaften, die direkter oder indirekter
Gesellschafter der Gesellschaft oder einer zur gleichen Gruppe wie die Gesellschaft gehörenden Konzerngesellschaft sind
(nachfolgend als die „verbundenen Unternehmen“ bezeichnet). Sie kann des Weiteren Garantien gewähren und Sicher-
heiten zugunsten Dritter stellen, um deren Verpflichtungen oder die Verpflichtungen ihrer verbundenen Unternehmen
zu besichern. Die Gesellschaft kann darüber hinaus ihr Vermögen ganz oder teilweise verpfänden, übertragen, belasten
oder in sonstiger Weise Sicherheiten dafür schaffen.
2.3 Die Gesellschaft kann außerdem in den Erwerb und das Management eines Portfolios von Patenten und/oder
sonstigen geistigen Schutzrechten gleich welcher Art oder Herkunft investieren.
2.4 Die Gesellschaft kann im Allgemeinen alle Methoden und Instrumente für ihre Investitionen zum Zwecke des
effizienten Managements derselben einsetzen, darunter auch Methoden und Instrumente, mit denen die Gesellschaft gegen
Kredit-, Währungs-, Zins- und andere Risiken abgesichert werden kann.
147100
L
U X E M B O U R G
2.5 Die Gesellschaft kann wirtschaftliche und/oder finanzielle Geschäfte im Zusammenhang mit direkten oder indi-
rekten Anlagen in bewegliches Vermögen und Immobilien abschließen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Erwerb,
Eigentum, Anmietung, Vermietung, Leasing, Verleih, Teilung, Abschöpfung, Rückforderung, Entwicklung, Erschließung,
Kultivierung, Erweiterung, Verkauf oder sonstige Veräußerung, Beleihung, Verpfändung oder Belastung in anderer Weise
von beweglichem Vermögen oder Immobilien.
2.6 Die vorgenannte Beschreibung ist im weitesten Sinne zu verstehen und die vorstehende Aufzählung erhebt keinen
Anspruch auf Vollständigkeit.
Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden,
welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird.
Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg).
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Rates der Geschäftsführer
verlegt werden. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderli-
chen Art und Weise gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.
4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer im
Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.
4.4 Sollte der Rat der Geschäftsführer entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale
Entwicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an
ihrem Gesellschaftssitz beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz bis zur endgültigen Beendigung dieser
außergewöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben
keine Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes
eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.
B. Gesellschaftskapital - Anteile
Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR), eingeteilt in zwölf-
tausendfünfhundert (12.500) Anteile mit einem Nominalwert von je einem Euro (1,- EUR).
5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-
zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.
5.3 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen.
Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit jeweils dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht über-
schreiten darf.
6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs, die Insolvenz
oder ein vergleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.
Art. 7. Anteilsregister - Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden
kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.
7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten
wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft
ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.
7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.
7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern mit
einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden.
7.5 Jede Übertragung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten gemäß Artikel 1690 des Code Civil
wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung zugestimmt
hat.
7.6 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters an neue Gesellschafter nur mit Zustimmung von
Gesellschaftern mit einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden. Eine derartige Zu-
147101
L
U X E M B O U R G
stimmung ist nicht erforderlich, wenn die Anteile an Eltern, Nachkommen oder den/die überlebende/n Ehepartner/in
übertragen werden oder jedem anderem gesetzlichen Erben des verstorbenen Gesellschafters.
C. Entscheidungen der Gesellschafter
Art. 8. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
8.1 Die Gesellschafterversammlung ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch das Gesetz und diese Satzung
übertragen wurden.
8.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.
8.3 Falls und solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, dürfen gemeinsame Ent-
scheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung vorbehalten wären, schriftlich gefasst werden. In diesem
Fall erhält jeder Gesellschafter den Text der Beschlüsse oder Entscheidungen in ausformulierter Form und übt sein
Stimmrecht schriftlich aus.
8.4 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschriften
des Abschnitts XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jeder Bezug auf die „Gesellschafter-
versammlung“ in der vorliegenden Satzung als Bezug auf den Alleingesellschafter, je nach Zusammenhang und soweit
anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingesellschafter ausgeübt.
Art. 9. Gesellschafterversammlung. Falls die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, muss jährlich
innerhalb von sechs (6) Monaten vor dem Ende des Geschäftsjahres mindestens eine Gesellschafterversammlung in Lu-
xemburg am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort abgehalten werden, wie in der Einberufungsbekanntmachung
zu dieser Versammlung genauer bestimmt. Andere Gesellschafterversammlungen finden an dem Ort und zu der Zeit statt,
welcher in der entsprechenden Einberufungsbekanntmachung genauer bestimmt werden. Falls alle Gesellschafter in einer
Versammlung anwesend oder vertreten sind und auf sämtliche Einberufungsformalitäten verzichtet haben, kann die Ge-
sellschafterversammlung auch ohne vorherige Ankündigung oder Veröffentlichung abgehalten werden.
Art. 10. Quorum und Abstimmung.
10.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.
10.2 Vorbehaltlich anderer Regelungen dieser Satzung oder des Gesetzes, die ein höheres Mehrheitsverhältnis vor-
sehen, bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von Gesellschaftern, die mehr als die
Hälfte des Gesellschaftskapitals halten. Falls diese Mehrheit in einer ersten Gesellschafterversammlung oder einer ersten
schriftlichen Konsultation der Gesellschafter nicht erreicht wird, können die Anteilseigner ein weiteres Mal mit derselben
Tagesordnung einberufen werden oder per Einschreiben dieselben schriftlichen Beschlussvorschläge erhalten und Ent-
scheidungen werden wirksam mit der Mehrheit der wirksam abgegebenen Stimmen gefasst, unabhängig vom Anteil des
durch sie vertretenen Gesellschaftskapitals.
Art. 11. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.
Art. 12. Änderung der Satzung. Eine Änderung der Satzung erfordert die Zustimmung (i) einer Mehrheit der Gesell-
schafter, die mindestens (ii) eine Mehrheit von drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertritt.
D. Geschäftsführung
Art. 13. Befugnisse des alleinigen Geschäftsführers -Zusammensetzung und Befugnisse des Rates der Geschäftsführer.
13.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Ge-
schäftsführer hat, bilden diese einen Rat der Geschäftsführer.
13.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „alleiniger Ge-
schäftsführer“ nicht ausdrücklich verwendet wird, ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Rat der Geschäftsführer“
als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer“ auszulegen.
13.3 Der Rat der Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse im Namen der Gesellschaft zu handeln
und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.
Art. 14. Ernennung, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
14.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung ernannt, welche ihre Bezüge und
Amtszeit festlegt.
14.2 Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund durch einen Beschluss von Gesellschaftern, die mehr als die
Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, ernannt oder abberufen werden.
14.3 Die Gesellschafterversammlung kann die Ernennung von Geschäftsführern zwei (2) unterschiedlicher Kategorien
beschließen, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Eine solche Klassifizierung
der Geschäftsführer muss ordnungsgemäß im Protokoll der betreffenden Gesellschafterbeschlüsse festgehalten und die
Geschäftsführer der Kategorie, der sie angehören, zugeordnet werden.
147102
L
U X E M B O U R G
Art. 15. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
15.1 Scheidet ein Geschäftsführer durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Insolvenz, Rücktritt oder aus einem anderen Grund
aus seinem Amt aus, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen die ur-
sprüngliche Amtszeit nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesellschafterversammlung ausgefüllt werden,
welche im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die endgültige Ernennung entscheidet.
15.2 Für den Fall, dass der alleinige Geschäftsführer aus seinem Amt ausscheidet, muss die frei gewordene Stelle
unverzüglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.
Art. 16. Einladung zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
16.1 Der Rat der Geschäftsführer versammelt sich auf Einberufung eines beliebigen Geschäftsführers. Die Sitzungen
des Rates der Geschäftsführer finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.
16.2 Die Geschäftsführer werden mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung anberaumten
Zeitpunkt zu jeder Sitzung des Rates der Geschäftsführer schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe
der Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Geschäftsführer
schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abgege-
ben haben, wobei eine Kopie eines solchen unterzeichneten Dokuments ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung
zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss
des Rates der Geschäftsführer bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.
16.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle
Einladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Rates
der Geschäftsführer diesen zugestimmt und diese unterzeichnen.
Art. 17. Durchführung von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
17.1 Der Rat der Geschäftsführer kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Rat der Ge-
schäftsführer kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise selbst ein Geschäftsführer sein muss
und der für die Protokollführung der Sitzungen des Rates der Geschäftsführer verantwortlich ist.
17.2 Sitzungen des Rates der Geschäftsführer werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Rates der Ge-
schäftsführer geleitet. In dessen Abwesenheit kann der Rat der Geschäftsführer ein anderes Mitglied des Rates der
Geschäftsführer durch einen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Mitglieder als Vorsitzenden pro
tempore ernennen.
17.3 Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer teilnehmen, indem er ein anderen
Geschäftsführer schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder durch ein anderes vergleichbares Kommunikationsmittel be-
vollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Geschäftsführer kann einen
oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.
17.4 Eine Sitzung des Rates der Geschäftsführer kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein
anderes Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu
hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel
ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung gilt als am Sitz der Ge-
sellschaft abgehalten.
17.5 Der Rat der Geschäftsführer kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest die Mehrheit seiner
Mitglieder in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.
17.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Rates der Geschäftsführer
teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden,
hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme. Sofern die Gesellschafterversammlung jedoch unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden Beschlüsse des Rates der Geschäftsführer nur dann wirksam gefasst, wenn sie von der Mehrheit
der Geschäftsführer einschließlich mindestens eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsführers der
Kategorie B (oder deren Vertreter) gefasst werden.
17.7 Der Rat der Geschäftsführer kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung,
per Faxschreiben, E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Jeder Geschäftsführer kann seine
Zustimmung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreffenden
Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.
Art. 18. Protokoll von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer - Protokoll der Entscheidungen des alleinigen Ge-
schäftsführers.
18.1 Das Protokoll einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer wird vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer,
falls vorhanden oder, im Falle seiner Abwesenheit, vom Vorsitzenden pro tempore und dem Schriftführer (falls vorhanden)
oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche
Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kate-
gorie B), werden solche Protokolle durch einen (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einen (1) Geschäftsführer der
Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet. Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsver-
147103
L
U X E M B O U R G
fahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer, falls
vorhanden, oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden solche Kopien oder Auszüge durch einen (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einen (1)
Geschäftsführer der Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet.
18.2 Die Entscheidungen des alleinigen Geschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom alleinigen
Geschäftsführer unterzeichnet wird. Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet.
Art. 19. Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Um-
ständen durch (i) die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder, für den Fall, dass die Gesellschaft mehrere
Geschäftsführer hat, durch die gemeinsame Unterschrift zwei (2) beliebiger Geschäftsführer wirksam verpflichtet; sofern
die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer
der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B), wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift min-
destens eines (1) Geschäftsführers der Kategorie A und eines (1) Geschäftsführers der Kategorie B (oder deren
Vertreter), oder (ii) durch die gemeinsamen Unterschriften oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/
denen eine Unterschriftsbefugnis durch den Rat der Geschäftsführer übertragen worden ist, wirksam verpflichtet.
E. Aufsicht und Prüfung der Gesellschaft
Art. 20. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
20.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der
Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungskommissare beaufsichtigt. Die Gesellschafterversammlung ernennt die
Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.
20.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
20.3 Die Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Recht der permanenten Überprüfung und Kontrolle aller Ge-
schäfte der Gesellschaft.
20.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember
2002 betreffend das Handelsregister und die Buchhaltung und den Jahresabschluss von Unternehmen, in der jeweils
gültigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige qualifizierte Wirtschaftsprüfer ernennen, entfällt die Funktion des
Rechnungsprüfers.
20.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die
Gesellschafterversammlung abberufen werden.
F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinne - Abschlagsdividenden
Art. 21. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am
einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.
Art. 22. Jahresabschluss und Gewinne.
22.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Rat der Geschäftsführer erstellt im
Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und
Verlustrechnung.
22.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage
der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.
22.3 Durch einen Gesellschafter erbrachte Einlagen in Rücklagen können mit Zustimmung dieses Gesellschafters
ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.
22.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage entsprechend herabgesetzt
werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.
22.5 Auf Vorschlag des Rates der Geschäftsführer bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den ge-
setzlichen Vorschriften und den Bestimmungen dieser Satzung wie der verbleibende Bilanzgewinn der Gesellschaft
verwendet werden soll.
22.6 Ausschüttungen an die Gesellschafter erfolgen proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehalt-
enen Anteile.
Art. 23. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
23.1 Der Rat der Geschäftsführer kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche
vom Rat der Geschäftsführer vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur
Verfügung stehen. Der ausschüttbare Betrag darf nicht die Summe der seit dem Ende des vergangenen Geschäftsjahres
angefallenen Gewinne, gegebenenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne und ausschüttbare Rücklagen, beziehungs-
weise vermindert durch vorgetragene Verluste oder Summen, die einer Rücklage zugeführt werden, welche nach dem
Gesetz von 1915 oder dieser Satzung nicht ausgeschüttert werden darf, übersteigen.
147104
L
U X E M B O U R G
23.2 Das Agio, andere Kapitalreserven und andere ausschüttbare Rücklagen können, im Einklang mit den Bestimmungen
des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung, frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.
G. Liquidation
Art. 24. Liquidation.
24.1 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Abwicklung durch
einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, die über die
Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit nichts anderes
bestimmt wird haben die Liquidatoren die weitestgehenden Rechte für die Verwertung der Vermögenswerte und die
Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
24.2 Der sich nach Verwertung der Vermögenswerte und Tilgung der Verbindlichkeiten ergebende Überschuss wird
an die Gesellschafter proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehaltenen Anteile verteilt.
H. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht
Art. 25. Anwendbares Recht. Für alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten gelten die Regelungen des
Gesetzes von 1915.
<i>Kosten und Auslageni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr tausend dreihundert
Euro.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache beherrscht und spricht, erklärt hiermit, dass, auf Wunsch der
oben genannten erschienen Partei, die vorliegenden Urkunde in englischer Sprache verfasst wurde, gefolgt von einer
deutschen Fassung; gemäß dem Wunsch derselben erschienen Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem
englischen und deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.
WORÜBER die vorliegende notarielle Urkunde in Luxemburg, an dem oben angegebenen Tag, erstellt wurde.
Nach Vorlesung der vorliegenden Urkunde an den Bevollmächtigten der erschienenen Partei, handelnd wie zuvor
erwähnt, dem Notar mit Vor- und Zunamen, Personenstand und Wohnort bekannt, hat besagte Bevollmächtigte mit Uns,
dem Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Signé: C. DOSTERT, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 septembre 2014. LAC/2014/40818. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Carole FRISING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
Luxembourg, le 10 septembre 2014.
Référence de publication: 2014142959/672.
(140162477) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2014.
Lewington S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 190.093.
STATUTES
In the year two thousand and fourteen, on the third of September.
Before Us Maître Henri BECK, notary residing in Echternach, Grand-Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
D.Law, a private limited liability company incorporated pursuant to the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,
having its registered address at Aerogolf Bloc A, 1, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 166 269, here represented by Ms. Peggy
Simon, with professional address at 9, Rabatt, L-6475 Echternach, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy
established on September 2, 2014.
The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the company appearing and the undersigned notary, will
remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing company, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows
the articles of association of a private limited liability company:
147105
L
U X E M B O U R G
Chapter I. Form, Name, Registered Office, Object, Duration.
Art. 1. Form. There is formed a private limited liability company (hereafter the “Company”), which will be governed
by the laws pertaining to such an entity, and in particular by the law of August 10
th
, 1915 on commercial companies as
amended (hereafter the “Law”), as well as by the present articles of association (hereafter the “Articles”).
The Company is initially composed of one sole shareholder, subscriber of all the shares. The Company may however
at any time be composed of several shareholders, but not exceeding forty (40) shareholders, notably as a result of the
transfer of shares or the issue of new shares.
Art. 2. Object. The purpose of the Company is the acquisition of ownership interests, in Luxembourg or abroad, in
any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such ownership interests. The Company
may in particular acquire by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and any other
securities, including without limitation bonds, debentures, certificates of deposit, trust units, any other debt instruments
and more generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever, including
partnerships. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. It
may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any
nature or origin whatsoever.
The Company may borrow in any form, except for borrowing from the public. It may issue notes, bonds, debentures
and any other kind of debt and/or equity securities, including but not limited to preferred equity certificates and warrants,
whether convertible or not in all cases. The Company may lend funds, including the proceeds of any borrowings and/or
issues of debt securities, to its subsidiaries, affiliated companies or to any other company. It may also give guarantees and
grant security interests in favor of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated
companies or any other company. The Company may further mortgage, pledge, transfer, encumber or otherwise hypo-
thecate all or some of its assets.
The Company may generally employ any techniques and utilize any instruments relating to its investments for the
purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against
creditors, currency fluctuations, interest rate fluctuations and other risks.
The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to
real estate or movable property, which directly or indirectly, further or relate to its purpose.
Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. Name. The Company will have the name of “Lewington S.à r.l.”.
Art. 5. Registered Office. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or,
in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Chapter II. Capital, Shares.
Art. 6. Subscribed Capital. The share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented
by twelve thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each.
In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share
in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment
of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make distribu-
tions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.
Art. 7. Increase and Reduction of Capital. The capital may be increased, or decreased, in one or several times at any
time by a decision of the sole shareholder or by a decision of the shareholders’ meeting voting with the quorum and
majority rules set out by article 18 of these Articles, or, as the case may be, by the Law for any amendment to these
Articles.
Art. 8. Shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one vote
at the general meetings of shareholders. Ownership of one or several shares carries implicit acceptance of the Articles
of the Company and the resolutions of the sole shareholder or the general meeting of shareholders.
Each share is indivisible towards the Company.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed
amongst them or not.
The sole shareholder may transfer freely its shares when the Company is composed of a sole shareholder. The shares
may be transferred freely amongst shareholders when the Company is composed of several shareholders. The shares
147106
L
U X E M B O U R G
may be transferred to non-shareholders only with the authorization of the general meeting of shareholders representing
at least three quarters of the capital, in accordance with article 189 of the Law.
The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal. Any such transfer is not
binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, in
accordance with article 1690 of the Civil Code.
The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the Law.
Art. 9. Incapacity, Bankruptcy or Insolvency of a Shareholder. The Company shall not be dissolved by reason of the
death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders.
Chapter III. Manager(s).
Art. 10. Manager(s), Board of Managers. The Company is managed by one or several managers. If several managers
have been appointed, they will constitute a board of managers.
The members of the board might be split into two categories, respectively denominated “Category A Managers” and
“Category B Managers”.
The managers need not be shareholders. The managers may be removed at any time, with or without legitimate cause,
by a resolution of the sole shareholder or by a resolution of the shareholders’ holding a majority of votes.
Each manager will be elected by the sole shareholder or by the shareholders’ meeting, which will determine their
number and the duration of their mandate.
Art. 11. Powers of the Manager(s). In dealing with third parties, the manager or the board of managers will have all
powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company’s object and provide that the terms of this article shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within
the competence of the manager or the board of managers.
Towards third parties, the Company shall be bound by the sole signature of its sole manager or, in case of plurality of
managers, by the joint signature of any two managers of the Company. In case the managers are split into two categories,
the Company shall obligatorily be bound by the joint signature of one Category A Manager and one Category B Manager.
If the manager or the board of managers is temporarily unable to act, the Company’s affairs may be managed by the
sole shareholder or, in case the Company has several shareholders, by the shareholders acting under their joint signatures.
The manager or board of managers shall have the rights to give special proxies for determined matters to one or more
proxyholders, selected from its members or not, either shareholders or not.
Art. 12. Day-to-day Management. The manager or the board of managers may delegate the day-to-day management
of the Company to one or several manager(s) or agent(s) and will determine the manager’s / agent’s responsibilities and
remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency. It is
understood that the day-to-day management is limited to acts of administration and thus, all acts of acquisition, disposition,
financing and refinancing have to obtain the prior approval from the board of managers.
Art. 13. Meetings of the Board of Managers. The meetings of the board of managers are held within the Grand Duchy
of Luxembourg.
The board of managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to be present, his
place will be taken by election among the/those managers present at the meeting.
The board of managers may elect a secretary from among its members.
A manager may be represented by another member of the board of managers.
The meetings of the board of managers may be convened by any two managers by any means of communication
including telephone or e-mail, provided that it contains a clear indication of the agenda of the meeting. The board of
managers may validly debate without prior notice if all the managers are present or represented.
The board of managers can only validly debate and make decisions if a majority of its members is present or represented
by proxies. In case the managers are split into two categories, at least one Category A Manager and one Category B
Manager shall be present or represented. Any decisions made by the board of managers shall require a simple majority
including at least the favorable vote of one Category A Manager and of one Category B Manager. In case of ballot, the
chairman of the meeting has a casting vote.
In case of a conflict of interest as defined in article 15 hereafter, the quorum requirement shall apply and for this
purpose the conflicting status of the affected manager(s) is disregarded.
One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of com-
munication initiated from Luxembourg enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate
and deliberate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a
decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by
all members having participated.
147107
L
U X E M B O U R G
A written decision, signed by all managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the board
of managers, which was duly convened and held.
Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content
signed by all members of the board of managers.
Art. 14. Liability - Indemnification. The manager or the board of managers assumes, by reason of its position, no
personal liability in relation to any commitment validly made by it in the name of the Company.
The Company shall indemnify any manager or officer and his heirs, executors and administrators, against any damages
or compensations to be paid by him/her or expenses or costs reasonably incurred by him/her, as a consequence or in
connection with any action, suit or proceeding to which he/she may be made a party by reason of his/her being or having
been a manager or officer of the Company, or, at the request of the Company, of any other company of which the
Company is a shareholder or creditor and by which he/she is not entitled to be indemnified, except in relation to matters
as to which he/she shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence, fraud or
wilful misconduct. In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters
covered by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified did
not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which such
manager or officer may be entitled.
Art. 15. Conflict of Interests. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm
shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the managers or any officer of the Company has a
personal interest in, or is a manager, associate, member, officer or employee of such other company or firm. Except as
otherwise provided for hereafter, any manager or officer of the Company who serves as a manager, associate, officer or
employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by
reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering and voting or
acting upon any matters with respect to such contract or other business.
Notwithstanding the above, in the event that any manager of the Company may have any personal interest in any
transaction conflicting with the interest of the Company, he shall make known to the board of managers such personal
interest and shall not consider or vote on any such transaction, and such transaction and such manager’s or officer’s
interest therein shall be reported to the sole shareholder or to the next general meeting of Shareholders.
Chapter IV. Shareholder(s).
Art. 16. General Meeting of Shareholders. If the Company is composed of one sole shareholder, the latter exercises
the powers granted by Law to the general meeting of shareholders.
If the Company is composed of no more than twenty-five (25) shareholders, the decisions of the shareholders may be
taken by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the board of managers to
the shareholders by any means of communication. In this latter case, the shareholders are under the obligation to, within
a delay of fifteen (15) days as from the receipt of the text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it
to the Company.
Unless there is only one sole shareholder, the shareholders may meet in a general meeting of shareholders upon call
in compliance with Law by the board of managers, failing which by the supervisory board, if it exists, failing which by
shareholders representing half the corporate capital. The notice sent to the shareholders in accordance with the Law will
specify the time and place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted.
If all the shareholders are present or represented at a shareholders’ meeting and if they state that they have been
informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.
A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing, by any means of communication
as his proxy another person who need not be a shareholder.
Shareholders’ meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgment of the board of
managers, which is final, circumstances of “force majeure” so require.
Art. 17. Powers of the Meeting of Shareholders. Any regularly constituted shareholders’ meeting of the Company
represents the entire body of shareholders.
Subject to all the other powers reserved to the manager or the board of managers by the Law or the Articles and
subject to the object of the Company, it has the broadest powers to carry out or ratify acts relating to the operations
of the Company.
Art. 18. Procedure, Vote. Any resolution whose purpose is to amend the present Articles or whose adoption is subject
by virtue of these Articles or, as the case may be, the Law, to the quorum and majority rules set for the amendment of
the Articles will be taken by a majority of shareholders representing at least three quarters of the capital.
The general meeting shall adopt resolutions by a simple majority of votes cast, provided that the number of shares
represented at the meeting represents at least one half of the share capital. Blank and mutilated ballots shall not be
counted.
One vote is attached to each share.
147108
L
U X E M B O U R G
Chapter V. Financial Year, Distribution of Profits.
Art. 19. Financial Year. The Company’s accounting year starts on January 1
st
and ends on December 31
st
of each
year.
Art. 20. Adoption of Financial Statements. At the end of each accounting year, the Company’s accounts are established
and the manager or the board of managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company’s
assets and liabilities.
The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the sole shareholder or, as the case may be, to
the general meeting of shareholders for approval.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 21. Appropriation of Profits. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses,
costs, amortisation, charges and provisions represents the net profit of the Company.
Every year five percent (5%) of the net profit will be transferred to the statutory reserve. This deduction ceases to be
compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but must be resumed till the reserve
fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatsoever, it has been broken into.
The balance is at the disposal of the shareholders.
The excess is distributed among the shareholders. However, the shareholders may decide, at the majority vote de-
termined by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve and interim dividends if any, be either carried
forward or transferred to an extraordinary reserve.
Art. 22. Interim Dividends. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
- Interim accounts are established by the manager or the board of managers;
- These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve;
- The decision to pay interim dividends is taken by the manager or the board of managers;
- The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Company
are not threatened and once five percent (5%) of the net profit of the current year has been allocated to the legal reserve.
Chapter VI. Dissolution, Liquidation.
Art. 23. Dissolution, Liquidation. At the time of winding up of the Company, the liquidation will be carried out by one
or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholder(s) who shall determine their powers and re-
muneration.
Chapter VII. Applicable Law.
Art. 24. Applicable Law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision
is made in these Articles.
<i>Transitory provisionsi>
The first accounting year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on December
31
st
, 2015.
<i>Subscription - Paymenti>
All the twelve thousand five hundred (12,500) shares have been subscribed by D.Law, prenamed.
All the shares have been fully paid in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-)
is at the disposal of the Company, as has been proven to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at one thousand one hundred Euro (EUR 1.100.-).
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
The sole shareholder resolves to:
1. Determine the number of manager at one (1).
2. Appoint the following person as Company’s manager:
- Mr. Marcel Stephany, born in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), on September 4
th
, 1951, residing at 23,
Cité Aline Mayrisch, L-7268 Bereldange, Grand Duchy of Luxembourg.
The duration of the manager’s mandate is unlimited.
3. Determine the address of the Company at 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxem-
bourg.
147109
L
U X E M B O U R G
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing party and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF the present deed was drawn up in Echternach, Grand-Duchy of Luxembourg, on the day named at the
beginning of this document.
The document having been read to the proxy of the Company appearing, he signed together with the notary the
present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille quatorze, le trois septembre.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
D.Law, une société à responsabilité limitée, constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège
social au Aerogolf Bloc A, 1, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 166269, représentée par Mademoiselle Peggy
Simon, ayant son adresse professionnelle au 9, Rabatt, L-6475 Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une
procuration donnée le 2 septembre 2014.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la mandataire de la comparante et le notaire
instrumentant, annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.
Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une
société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:
Chapitre I
er
. Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée.
Art. 1
er
. Forme. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité
(ci-après la «Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après la «Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après les «Statuts»).
La Société comporte initialement un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales. Elle peut cependant,
à toute époque, comporter plusieurs associés, dans la limite de quarante (40) associés, par suite notamment, de cession
ou transmission de parts sociales ou de création de parts sociales nouvelles.
Art. 2. Objet. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans d’autres
sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier
acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de partici-
pation, incluant sans limitation, des obligations, tout instrument de dette, créances, certificats de dépôt, des unités de
trust et en général toute valeur ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée, y compris des sociétés
de personnes. Elle pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société ou
entreprise. Elle pourra en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets ou d’autres droits de
propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit à l’exception d’un emprunt public. Elle peut procéder,
par voie de placement privé, à l’émission de parts et d’obligations et d’autres titres représentatifs d’emprunts et/ou de
créances incluant, sans limitation, l’émission de «PECS» et des «warrants», et ce convertibles ou non.
La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d’obligations, à ses
filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de
tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre
société. La Société pourra en outre gager, nantir, céder, grever de charges tout ou partie de ses avoirs ou créer, de toute
autre manière, des sûretés portant sur tout ou partie de ses avoirs.
La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue
d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les créanciers, fluctuations
monétaires, fluctuations de taux d’intérêt et autres risques.
La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tout transfert de
propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social ou s’y
rapportent de manière directe ou indirecte.
Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Dénomination. La Société a comme dénomination «Lewington S.à r.l.».
Art. 5. Siège Social. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
147110
L
U X E M B O U R G
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée
générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Chapitre II. Capital, Parts Sociales.
Art. 6. Capital Souscrit. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500,-) représenté par douze
mille cinq cents (12.500) parts sociales ayant une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-) chacune.
En plus du capital social, un compte de prime d’émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part
sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L’avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer
le remboursement en cas de rachat des parts sociales des associés par la Société, pour compenser des pertes nettes
réalisées, pour effectuer des distributions aux associés, ou pour être affecté à la réserve légale.
Art. 7. Augmentation et Diminution du Capital Social. Le capital émis de la Société peut être augmenté ou réduit, en
une ou en plusieurs fois, par une résolution de l’associé unique ou des associés adoptée aux conditions de quorum et de
majorité exigées par les Statuts ou, selon le cas, par la Loi pour toute modification des Statuts.
Art. 8. Parts Sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et
dans tout l’actif social et une voix à l’assemblée générale des associés. La propriété d’une ou de plusieurs parts sociales
emporte de plein droit adhésion aux Statuts de la Société et aux décisions de l’associé unique ou des associés.
Chaque part est indivisible à l’égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire
commun pris parmi eux ou en dehors d’eux.
Les cessions ou transmissions de parts sociales détenues par l’associé unique sont libres, si la Société a un associé
unique. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés, si la Société a plusieurs associés. Les parts sociales ne
peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément des associés représentant les trois quarts
du capital social, en conformité avec l’article 189 de la Loi.
La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé. De telles cessions ne
sont opposables à la Société et aux tiers qu’après qu’elles aient été signifiées à la Société ou acceptées par elle confor-
mément à l’article 1690 du Code Civil.
La Société peut racheter ses propres parts sociales conformément aux dispositions légales.
Art. 9. Incapacité, Faillite ou Déconfiture d’un Associé. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la
suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.
Chapitre III. Gérant(s).
Art. 10. Gérants, Conseil de Gérance. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont
nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Les membres peuvent ou non être répartis en deux catégories, nommés
respectivement «Gérants de catégorie A» et «Gérants de catégorie B».
Les gérants ne doivent pas être obligatoirement associés. Ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans
justification légitime, par décision de l’associé unique ou des associés représentant une majorité des voix.
Chaque gérant sera nommé par l’associé unique ou les associés, selon le cas, qui détermineront leur nombre et la
durée de leur mandat.
Art. 11. Pouvoirs du/des Gérant(s). Dans les rapports avec les tiers, le gérant ou le conseil de gérance a tout pouvoir
pour agir au nom de la Société dans toutes les circonstances et pour effectuer et approuver tout acte et opération
conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de
la compétence du gérant ou du conseil de gérance.
Envers les tiers, la Société est valablement engagée par la signature de son gérant unique ou, en cas de pluralité de
gérants, par la signature conjointe de deux gérants. Dans l’éventualité où deux catégories de gérants sont créées, la Société
sera obligatoirement engagée par la signature conjointe d’un Gérant de catégorie A et d’un Gérant de catégorie B.
Si le gérant ou le conseil de gérance est temporairement dans l’impossibilité d’agir, la Société pourra être gérée par
l’associé unique ou en cas de pluralité d’associés, par les associés agissant conjointement.
Le gérant ou le conseil de gérance a le droit de déléguer certains pouvoirs déterminés à un ou plusieurs mandataires,
sélectionnés parmi ses membres ou pas, qu’ils soient associés ou pas.
Art. 12. Gestion Journalière. Le gérant ou le conseil de gérance peut déléguer la gestion journalière de la Société à un
ou plusieurs gérant(s) ou mandataire(s) et déterminera les responsabilités et rémunérations (éventuelle) des gérants/
mandataires, la durée de la période de représentation et toute autre condition pertinente de ce mandat. Il est convenu
147111
L
U X E M B O U R G
que la gestion journalière se limite aux actes d’administration et qu’en conséquence, tout acte d’acquisition, de disposition,
de financement et refinancement doit être préalablement approuvé par le gérant ou le conseil de gérance.
Art. 13. Réunions du Conseil de Gérance. Les réunions du conseil de gérance sont tenues au Grand-Duché de Lu-
xembourg.
Le conseil de gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président ne peut être présent, un remplaçant
sera élu parmi les gérants présents à la réunion.
Le conseil de gérance peut élire un secrétaire parmi ses membres.
Un gérant peut en représenter un autre au conseil.
Les réunions du conseil de gérance sont convoquées par deux gérants par n’importe quel moyen de communication
incluant le téléphone ou le courrier électronique, à condition qu’il contienne une indication claire de l’ordre du jour de
la réunion. Le conseil de gérance peut valablement délibérer sans convocation préalable si tous les gérants sont présents
ou représentés.
Le conseil de gérance ne peut délibérer et prendre des décisions valablement que si une majorité de ses membres est
présente ou représentée par procurations. Dans l’éventualité où deux catégories de gérants sont créées, au moins un
Gérant de catégorie A et un Gérant de catégorie B devra être présent ou représenté.
Toute décision du conseil de gérance doit être prise à majorité simple, avec au moins le vote affirmatif d’un Gérant
de catégorie A et d’un Gérant de catégorie B dans l’éventualité où deux catégories de gérants sont créées. En cas de
ballottage, le président du conseil a un vote prépondérant.
En cas de conflit d’intérêt tel que défini à l’article 15 ci-après, les exigences de quorum s’appliqueront et, à cet effet, il
ne sera pas tenu compte de l’existence d’un tel conflit dans le chef du ou des gérants concernés pour la détermination
du quorum.
Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par «conference call» ou par tout autre
moyen similaire de communication, à partir du Luxembourg, ayant pour effet que tous les gérants participant et délibérant
au conseil puissent se comprendre mutuellement.
Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion. Cette décision peut
être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signé(s) par
tous les participants.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision
prise à une réunion du conseil de gérance, dûment convoquée et tenue.
Cette décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même
contenu, signé(s) par tous les participants.
Art. 14. Responsabilité, Indemnisation. Le gérant ou le conseil de gérance ne contracte à raison de sa fonction, aucune
obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par ui au nom de la Société.
La Société devra indemniser tout gérant ou mandataire et ses héritiers, exécutant et administrant, contre tous dom-
mages ou compensations devant être payés par lui/elle ainsi que les dépenses ou les coûts raisonnablement engagés par
lui/elle, en conséquence ou en relation avec toute action, procès ou procédures à propos desquelles il/elle pourrait être
partie en raison de son/sa qualité ou ancienne qualité de gérant ou mandataire de la Société, ou, à la requête de la Société,
de toute autre société où la Société est un associé ou un créancier et par quoi il/elle n’a pas droit à être indemnisé(e),
sauf si cela concerne des questions à propos desquelles il/elle sera finalement déclaré(e) impliqué(e) dans telle action,
procès ou procédures en responsabilité pour négligence grave, fraude ou mauvaise conduite préméditée. Dans l’hypothèse
d’une transaction, l’indemnisation sera octroyée seulement pour les points couverts par l’accord et pour lesquels la Société
a été avertie par son avocat que la personne à indemniser n’a pas commis une violation de ses obligations telle que décrite
ci-dessus. Les droits d’indemnisation ne devront pas exclure d’autres droits auxquels tel gérant ou mandataire pourrait
prétendre.
Art. 15. Conflit d’Intérêt. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d’autres sociétés ou firmes ne sera
affecté ou invalidé par le fait qu’un ou plusieurs gérants ou fondés de pouvoirs de la Société y auront un intérêt personnel,
ou en seront gérant, associé, fondé de pouvoirs ou employé. Sauf dispositions contraires ci-dessous, un gérant ou fondé
de pouvoirs de la Société qui remplira en même temps des fonctions d’administrateur, associé, fondé de pouvoirs ou
employé d’une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d’affaires,
ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, automatiquement empêché de donner son avis
et de voter ou d’agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou autre affaire.
Nonobstant ce qui précède, au cas où un gérant ou fondé de pouvoirs aurait un intérêt personnel dans une opération
de la Société, entrant en conflit avec les intérêts de la Société, il en avisera le conseil de gérance et il ne pourra prendre
part aux délibérations ou émettre un vote au sujet de cette opération. Cette opération ainsi que l’intérêt personnel du
gérant ou du fondé de pouvoirs seront portés à la connaissance de l’associé unique ou des associés au prochain vote par
écrit ou à la prochaine assemblée générale des associés.
147112
L
U X E M B O U R G
Chapitre IV. Associé(s).
Art. 16. Assemblée Générale des Associés. Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs
qui sont dévolus par la Loi à l’assemblée générale des associés.
Si la Société ne comporte pas plus de vingt-cinq (25) associés, les décisions des associés peuvent être prises par vote
écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par le conseil de gérance aux associés par le biais de tout
moyen de communication. Dans ce dernier cas, les associés ont l’obligation d’émettre leur vote écrit et de l’envoyer à la
Société, dans un délai de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.
A moins qu’il n’y ait qu’un associé unique, les associés peuvent se réunir en assemblée générale conformément aux
conditions fixées par la Loi sur convocation par le conseil de gérance, ou à défaut, par le conseil de surveillance, s’il existe,
ou à défaut, par des associés représentant la moitié du capital social. La convocation envoyée aux associés en conformité
avec la Loi indiquera la date, l’heure et le lieu de l’assemblée et elle contiendra l’ordre du jour de l’assemblée générale
ainsi qu’une indication des affaires qui y seront traitées.
Au cas où tous les associés sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour de
l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.
Tout associé peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par tout moyen de communication, un man-
dataire, lequel n’est pas obligatoirement associé.
Les assemblées générales des associés, y compris l’assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l’étranger chaque
fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le conseil de gérance.
Art. 17. Pouvoirs de l’Assemblée Générale. Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée repré-
sente l’ensemble des associés.
Sous réserve de tous autres pouvoirs réservés au conseil de gérance en vertu de la Loi ou les Statuts et conformément
à l’objet social de la Société, elle a les pouvoirs les plus larges pour décider ou ratifier tous actes relatifs aux opérations
de la Société.
Art. 18. Procédure - Vote. Toute décision dont l’objet est de modifier les présents Statuts ou dont l’adoption est
soumise par les présents Statuts, ou selon le cas, par la Loi aux règles de quorum et de majorité fixée pour la modification
des Statuts sera prise par une majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital.
L’assemblée générale adoptera les décisions à la majorité simple des voix émises, à condition que le nombre des parts
sociales représentées à l’assemblée représente au moins la moitié du capital social. Les votes blancs et les votes à bulletin
secret ne devront pas être pris en compte.
Chaque action donne droit à une voix.
Chapitre V. Année Sociale, Répartition.
Art. 19. Année Sociale. L’année sociale commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Art. 20. Approbation des Comptes Annuels. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont
établis et le gérant ou le conseil de gérance prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.
Les comptes annuels et le compte des profits et pertes sont soumis à l’agrément de l’associé unique ou, suivant le cas,
des associés.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 21. Affectation des Résultats. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais,
charges et amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais
devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.
Le solde du bénéfice net est à la disposition des associés.
Le surplus est distribué entre les associés. Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la Loi, décider
qu'après déduction de la réserve légale et des dividendes intérimaires le cas échéant, le bénéfice sera reporté à nouveau
ou transféré à une réserve spéciale.
Art. 22. Dividendes Intérimaires. Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve
du respect des conditions suivantes:
- Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance;
- Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître
un bénéfice;
- Le gérant ou le conseil de gérance est seul compétent pour décider de la distribution d'acomptes sur dividendes;
147113
L
U X E M B O U R G
- Le paiement n'est effectué par la Société qu'après avoir obtenu l’assurance que les droits des créanciers ne sont pas
menacés et une fois que cinq pour cent (5 %) du profit net de l’année en cours a été attribué à la réserve légale.
Chapitre VI. Dissolution, Liquidation.
Art. 23. Dissolution, Liquidation. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou
plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associé(s) qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Chapitre VII. Loi Applicable.
Art. 24. Loi Applicable. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence
à la Loi.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2015.
<i>Souscription - Libérationi>
Toutes les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ont été souscrites par D.Law, préqualifiée.
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de douze
mille cinq cents Euro (EUR 12.500,-) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui
le reconnaît expressément.
<i>Fraisi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille cent Euros (EUR 1.100.-).
<i>Décisions de l'associé uniquei>
L’associé unique décide de:
1. Déterminer le nombre de gérant à un (1).
2. Nommer la personne suivante en tant que gérant de la Société:
- Monsieur Marcel Stephany, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) le 4 septembre 1951, résidant pro-
fessionnellement au 23, Cité Aline Mayrisch, L-7268 Bereldange, Grand-Duché de Luxembourg.
La durée du mandat des gérants est illimitée.
3. Déterminer l’adresse du siège social au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, Fait et passé à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec
le notaire.
Signé: P. SIMON, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 05 septembre 2014. Relation: ECH/2014/1600. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): J.-M. MINY.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Echternach, le 11 septembre 2014.
Référence de publication: 2014142894/490.
(140162239) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2014.
Fibalux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9990 Weiswampach, 15B, Duarrefstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 143.459.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 12 septembre 2014.
Référence de publication: 2014142785/10.
(140162156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2014.
147114
L
U X E M B O U R G
Capula ESS Lux 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 7, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 177.365.
In the year two thousand and fourteen, on the fourth day of September,
Before Maître Joëlle Baden, notary, residing in Luxembourg,
There appeared:
Capula European Special Situations Fund L.P., an exempted limited partnership incorporated and existing under the
laws of the Cayman Islands, having its registered office at PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman
Islands, registered with the Registrar of Exempted Limited Partnerships under number MC-70819,
represented by its general partner, Capula European Special Situations Fund (GP) L.P., an exempted limited partnership
incorporated and existing under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at PO Box 309, Ugland House,
Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands, registered with the Registrar of Exempted Limited Partnerships under number
MC-70808,
represented by its general partner, Capula European Special Situations Fund (GP) Limited, a limited company incor-
porated and existing under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at PO Box 309, Ugland House,
Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands, registered with the Registrar of Companies under number MC-274461,
duly represented by Mr Jeff Braun, Maître en droit, having his professional address in Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, by virtue of a proxy given on 28 August 2014 in Potsdam.
The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to
this deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party is the sole member of Capula ESS Lux 1 S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its
registered office at 7, Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, recorded with the Luxembourg Trade and Com-
panies' Register under number B 177.365, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on 2 May 2013,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1620 on 6 July 2013 (hereafter the "Company").
The Articles were amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary on 4 June 2014, published in
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2193 on 19 August 2014.
The appearing party, representing the entire share capital, requested the undersigned notary to act that the agenda of
the meeting is as follows:
<i>Agendai>
1. Increase of the share capital of the Company from its current amount of two million two hundred fifty thousand
one hundred twenty-five euro (EUR 2,250,125.-), represented by two hundred four thousand five hundred fifty-eight
(204,558) class A shares and two million forty-five thousand five hundred sixty-seven (2,045,567) class B shares, having
a par value of one euro (EUR 1.-) each, up to three million one hundred fifty thousand one hundred twenty-five euro
(EUR 3,150,125.-), through the issue of eighty-one thousand eight hundred seventeen (81,817) new class A shares and
eight hundred eighteen thousand one hundred eighty-three (818,183) new class B shares, having a par value of one euro
(EUR 1.-) each, against a payment in cash;
2. Subsequent amendment of Article 5.1 of the articles of association of the Company.
The appearing party, representing the entire share capital, took the following resolutions:
<i>First resolution:i>
The sole member resolves to increase the share capital of the Company from its current amount of two million two
hundred fifty thousand one hundred twenty-five euro (EUR 2,250,125.-), represented by two hundred four thousand five
hundred fifty-eight (204,558) class A shares and two million forty-five thousand five hundred sixty-seven (2,045,567) class
B shares, having a par value of one euro (EUR 1.-) each, up to three million one hundred fifty thousand one hundred
twenty-five euro (EUR 3,150,125.-), through the issue of eighty-one thousand eight hundred seventeen (81,817) new class
A shares and eight hundred eighteen thousand one hundred eighty-three (818,183) new class B shares, having a par value
of one euro (EUR 1.-) each.
<i>Subscription and paymenti>
The eighty-one thousand eight hundred seventeen (81,817) new class A shares and eight hundred eighteen thousand
one hundred eighty-three (818,183) new class B shares have been subscribed by Capula European Special Situations Fund
L.P., aforementioned, at a total price of nine hundred thousand euro (EUR 900,000.-) entirely allocated to the share
capital.
The eighty-one thousand eight hundred seventeen (81,817) new class A shares and eight hundred eighteen thousand
one hundred eighty-three (818,183) new class B shares have been fully paid up in cash by Capula European Special
Situations Fund L.P., aforementioned, and the total amount of nine hundred thousand euro (EUR 900,000.-) is at the
disposal of the Company, as it has been shown to the undersigned notary.
147115
L
U X E M B O U R G
<i>Second resolution:i>
As a consequence of the above resolution, the sole member resolves to amend Article 5.1 of the articles of association
of the Company which shall henceforth be read as follows:
“ 5.1. The Company's share capital is set at three million one hundred fifty thousand one hundred twenty-five euro
(EUR 3,150,125.-), consisting of:
- two hundred eighty-six thousand three hundred seventy-five (286,375) class A shares, having a par value of one euro
(EUR 1.-) each (the “Class A Shares”); and
- two million eight hundred sixty-three thousand seven hundred fifty (2,863,750) class B shares, having a par value of
one euro (EUR 1.-) each (the “Class B Shares”, and together with the Class A Shares, the “Shares”).”
There being no further business, the meeting is closed.
WHEREOF, this deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that upon request of the proxyholder
of the appearing person, this deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the same appearing
proxyholder of the appearing person and in case of divergences between the English and the French texts, the English
version will be prevailing.
The document having been read to the proxyholder of the above appearing party known to the notary, such person
signed together with the notary this deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille quatorze, le quatre septembre,
Par devant Maître Joëlle Baden, notaire, résidant à Luxembourg,
A comparu:
Capula European Special Situations Fund L.P., un exempted limited partnership, constitué et existant sous les lois des
Iles Caïmans, ayant son siège social à PO Box 309, Ugland House, Grand Caïman, KY1-1104, Iles Caïmans, immatriculé
auprès du Registrar of Exempted Limited Partnerships sous le numéro MC-70819,
représenté par son gérant commandité, Capula European Special Situations Fund (GP) L.P, un exempted limited part-
nership, constitué et existant sous les lois des Iles Caïmans, ayant son siège social à PO Box 309, Ugland House, Grand
Caïman, KY1-1104, Iles Caïmans, immatriculé auprès du Registrar of Exempted Limited Partnerships sous le numéro
MC-70808,
représenté par son gérant commandité, Capula European Special Situations Fund (GP) Limited, une société à respon-
sabilité limitée (limited company), constituée et existant sous les lois des Iles Caïmans, ayant son siège social à PO Box
309, Ugland House, Grand Caïman, KY1-1104, Iles Caïmans, immatriculé auprès du Registrar of Companies sous le
numéro MC-274461,
dûment représenté par M. Jeff Braun, Maître en droit, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, Grand-duché
de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 28 août 2014 à Potsdam.
Ladite procuration, signée ne varietur par le mandataire du comparant et par le notaire soussigné, restera annexée au
présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Le comparant est l'associé unique de Capula ESS Lux 1 S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège
social au 7, Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 177.365, constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 2 mai 2013, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1620 du 6 juillet 2013 (ci-après la "Société").
Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire soussigné en date du 4 juin 2014, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2193 du 19 août 2014.
Le comparant, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire soussigné de prendre acte que l'ordre du
jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Agendai>
1. Augmentation du capital social de la Société de son montant actuel de deux millions deux cent cinquante mille cent
vingt-cinq euros (EUR 2.250.125,-) représenté par deux cent quatre mille cinq cent cinquante-huit (204.558) parts sociales
de catégorie A et deux millions quarante-cinq mille cinq cent soixante-sept (2.045.567) parts sociales de catégorie B,
d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, au montant de trois millions cent cinquante mille cent vingt-cinq
euros (EUR 3.150.125,-) par l'émission de quatre-vingt-un mille huit cent dix-sept (81.817) nouvelles parts sociales de
catégorie A et huit cent dix-huit mille cent quatre-vingt-trois (818.183) nouvelles parts sociales de catégorie B d'une
valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, en échange d'un paiement en numéraire;
2. Modification subséquente de l'article 5.1 des statuts de la Société.
Le comparant, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
147116
L
U X E M B O U R G
<i>Première résolution:i>
L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société de son montant actuel de deux millions deux cent
cinquante mille cent vingt-cinq euros (EUR 2.250.125,-) représenté par deux cent quatre mille cinq cent cinquante-huit
(204.558) parts sociales de catégorie A et deux millions quarante-cinq mille cinq cent soixante-sept (2.045.567) parts
sociales de catégorie B, d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, au montant de trois millions cent cinquante
mille cent vingt-cinq euros (EUR 3.150.125,-) par l'émission de quatre-vingt-un mille huit cent dix-sept (81.817) nouvelles
parts sociales de catégorie A et huit cent dix-huit mille cent quatre-vingt-trois (818.183) nouvelles parts sociales de
catégorie B d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune.
<i>Souscription et paiementi>
Les quatre-vingt-un mille huit cent dix-sept (81.817) nouvelles parts sociales de catégorie A et huit cent dix-huit mille
cent quatre-vingt-trois (818.183) nouvelles parts sociales de catégorie B ont été souscrites par Capula European Special
Situations Fund L.P., susmentionné, pour un montant de neuf cent mille euros (EUR 900.000,-) intégralement alloué au
capital social.
Les quatre-vingt-un mille huit cent dix-sept (81.817) nouvelles parts sociales de catégorie A et huit cent dix-huit mille
cent quatre-vingt-trois (818.183) nouvelles parts sociales de catégorie B ainsi souscrites ont été entièrement libérées en
numéraire par Capula European Special Situations Fund L.P., susmentionné, et le montant total de neuf cent mille euros
(EUR 900.000,-) est à la libre disposition de la Société tel qu'il a été démontré au notaire soussigné.
<i>Seconde résolution:i>
A la suite de la résolution précédente, l'associé unique a décidé de modifier l'article 5.1 des statuts de la Société, qui
aura désormais la teneur suivante:
« 5.1. La Société a un capital social de trois millions cent cinquante mille cent vingt-cinq euros (EUR 3.150.125,-)
représenté par:
- deux cent quatre-vingt-six mille trois cent soixante-quinze (286.375) parts sociales de catégorie A ayant une valeur
nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune (les «Parts Sociales A»); et par
- deux millions huit cent soixante-trois mille sept cent cinquante (2.863.750) parts sociales de catégorie B ayant une
valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune (les «Parts Sociales B» et ensemble avec les Parts Sociales A, les «Parts
Sociales»).»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du mandataire du comparant, le présent
acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du mandataire de ce même comparant et en
cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire instrumentant par nom,
prénom usuel, état et demeure, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. BRAUN et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 septembre 2014. LAC / 2014 / 41865. Reçu soixante quinze euros € 75,-
<i>Le Receveur ff.i> (signé): FRISING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.
Luxembourg, le 11 septembre 2014.
Référence de publication: 2014142001/152.
(140161736) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2014.
Censi SP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 21.630.
Der Jahresabschluss vom 31.12.2013 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Compliance Partners S.A.
Signature
Référence de publication: 2014144004/11.
(140163539) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2014.
147117
L
U X E M B O U R G
Saint-Georges, Société Anonyme.
Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.
R.C.S. Luxembourg B 122.601.
L'an mille quatorze, le neuf septembre.
Par-devant, Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie:
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "SAINT-GEORGES", avec siège social à
L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis, constituée suivant acte de Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence
à Luxembourg, en date du 1
er
décembre 2006, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 163
du 12 février 2007 et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 122601,
(la «Société»). Les statuts de la Société (les «Statuts») furent modifiés pour la dernière fois suivant acte de Maître Jean
SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, en date du 18 août 2011, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 2640 du 29 octobre 2011.
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Romain Zimmer, expert-comptable, demeurant profession-
nellement à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Mustafa Nezar, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Monique DRAUTH, salariée, demeurant professionnellement à Lu-
xembourg
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ORDRE DU JOUR:
1. Réduction du capital social de la Société d’un montant de cinq millions neuf cent soixante-neuf mille euros (EUR
5.969.000,-) pour le porter de son montant actuel de six millions d’euros (EUR 6.000.000,-) représenté par soixante mille
(60.000) actions avec une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, à trente et un mille euros (EUR 31.000,-)
par voie de rachat et d'annulation subséquente par la Société de cinquante-neuf mille six cent quatre-vingt-dix (59.690)
actions (les «Actions Rachetées et Annulées»), et remboursement au détenteur des Actions Rachetées et Annulées de
la valeur nominale des actions d'un montant de cent euros (EUR 100,-) chacune (le «Prix de Rachat»).
2. Autorisation et pouvoir donnés à tout administrateur de la Société, chacun agissant individuellement, sous sa propre
signature, afin de procéder pour le compte de la Société, au paiement du Prix de Rachat au détenteur des Actions
Rachetées et Annulées et de déterminer la date et autres formalités de ce rachat.
3. Modification du premier alinéa de l’article 5 des Statuts.
4. Modification du registre d'actions de la Société afin d'y refléter les modifications ci-dessus et pouvoir et autorité
accordés à tout administrateur de la Société agissant individuellement avec plein pouvoir de substitution pour procéder
pour le compte de la Société à la modification du registre d'actions de la Société.
5. Divers.
II.- Que le mandataire de l’actionnaire unique représenté, ainsi que le nombre d'actions qu'il détient sont indiqués sur
une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de l’actionnaire
unique représenté ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-
verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Restera pareillement annexée aux présentes la procuration de l’actionnaire unique représenté, après avoir été signée
"ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.
III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de réduire le capital social de la Société entièrement souscrit et libéré d’un montant de cinq millions
neuf cent soixante-neuf mille euros (EUR 5.969.000,-) pour le porter de son montant actuel de six millions d’euros (EUR
6.000.000,-) représenté par soixante mille (60.000) actions avec une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune,
à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) par voie de rachat et d'annulation subséquente par la Société des Actions
Rachetées et Annulées, et remboursement au détenteur des Actions Rachetées et Annulées du Prix de Rachat.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide d'autoriser et de donner pouvoir à tout administrateur de la Société, chacun agissant individuel-
lement, sous sa seule signature, afin de procéder au nom de la Société au paiement du Prix de Rachat au détenteur des
Actions Rachetées et Annulées et de déterminer la date et autres formalités de ce paiement, sans toutefois que le paiement
147118
L
U X E M B O U R G
ne puisse être opéré avant l’expiration du délai de trente jour à compter du jour de la publication dans le Mémorial C
du présent acte tel que prévu à l’article 69 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciale.
<i>Troisième résolutioni>
Suite à ce qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des Statuts qui aura désormais
la teneur suivante:
Art. 5. (1
er
alinéa). "Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trois cent dix
(310) actions avec une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune."
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier le registre d'actions de la Société afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus et
autorise et donne pouvoir à tout administrateur de la Société agissant individuellement, avec plein pouvoir de substitution,
afin de procéder pour le compte de la Société à la modification du registre d'actions de la Société.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
à raison des présentes est évalué à environ mille sept cents euros (EUR 1.700,-).
Plus rien n'étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont
requis de documenter le présent acte en langue française, suivi d'une version anglaise, et en cas de divergence entre le
texte français et le texte anglais, le texte français fera foi.
DONT ACTE, Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau, connus du notaire instrumentaire par leurs
noms, prénoms, états et demeures, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Suit la version anglaise du texte qui précède:
In the year two thousand and fourteen, on the ninth day of September.
Before the undersigned Maître Léonie GRETHEN, notary residing in Luxembourg.
Was held
an Extraordinary General Meeting of shareholders of "SAINTGEORGES", a société anonyme, having its registered
office in L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis, incorporated by a deed of Maître Joseph ELVINGER, notary
residing in Luxembourg, on 1
st
December 2006, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number
163 of 12
th
February 2007 and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 122601,
(the "Company"). The articles of incorporation (the “Articles”) have been amended for the last time by a deed of Maître
Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, on 18
th
August 2011, published in the Mémorial, Recueil Sociétés et As-
sociations, number 2640 of 29 October 2011.
The meeting was opened by Mr Romain Zimmer, expert comptable, residing professionally in Luxembourg, being in
the chair,
who appointed as secretary Mr. Mustafa Nezar, jurist, residing professionally in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Ms Monique Drauth, employee, residing professionally in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1. Capital decrease by the amount of five million nine hundred sixty-nine thousand Euros (EUR 5,969,000.-) to bring
it from six million Euros (EUR 6,000,000.-) represented by six thousand (6,000) shares with a par value of one hundred
Euros (EUR 100.-) each, to thirty-one thousand Euros (EUR 31,000.-), represented by three hundred and ten (310) shares
with a par value of one hundred Euros (EUR 100.-) each, by way of the redemption and subsequent cancellation by the
Company of fifty-nine thousand six hundred ninety (59,690) shares (the “Redeemed and Cancelled Shares”), with reim-
bursement to the holder of the Redeemed and Cancelled Shares of the par value of the shares in an amount of one
hundred Euro (EUR 100,-) each (the “Redemption Price”).
2. Authorization and empowerment of any director of the Company, each acting individually, under his or her sole
signature, to proceed, on behalf of the Company, with the payment of the Redemption Price to the holder of the Re-
deemed and Cancelled Shares and to fix the date and other formalities of such payment.
3. Subsequent amendment of the first paragraph of Article 5 of Articles.
4. Amendment to the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority
given to any director of the Company acting individually with full power of substitution to proceed on behalf of the
Company to the amendment in the shares' register of the Company.
5. Miscellaneous.
147119
L
U X E M B O U R G
II. The proxyholder of the represented shareholder and the number of his shares are shown on an attendance list; this
attendance list, signed by the proxyholder of the represented shareholder, the board of the meeting and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed.
The proxy of the represented shareholder will also remain annexed to the present deed.
III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are represented at the present general meeting,
so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.
After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting decides to decrease the Company’s subscribed and paid-up share capital by the amount of five
million nine hundred sixty-nine thousand Euros (EUR 5,969,000.-) to bring it from six million Euros (EUR 6,000,000.-)
represented by six thousand (6,000) shares with a par value of one hundred Euros (EUR 100.-) each, to thirty-one thousand
Euros (EUR 31,000.-), represented by three hundred and ten (310) shares with a par value of one hundred Euros (EUR
100.-) each, by way of the redemption and subsequent cancellation by the Company the Redeemed and Cancelled Shares,
with reimbursement to the sole shareholder of the Redeemed and Cancelled Shares of the Redemption Price.
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolves to authorize and empower any director of the Company, each acting individually, under his or
her sole signature, to proceed, on behalf of the Company, with the payment of the Redemption Price to the holder of
the Redeemed and Cancelled Shares and to fix the date and other formalities of such payment, but not before a period
of thirty days from the publication of the present deed in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations pursuant
to article 69 of the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the above resolutions, the general meeting decides to amend the first paragraph of article 5 of
the Articles, which will henceforth have the following wording:
Art. 5. (1
st
paragraph). "The share capital is set at thirty-one thousand Euros (EUR 31,000.-) represented by three
hundred and ten (310) shares with a par value of one hundred Euros (100,- EUR) each.”.
<i>Fourth resolutioni>
The Meeting resolves to amend the shares' register of the Company in order to reflect the above changes with power
and authority given to any director of the Company acting individually with full power of substitution to proceed on behalf
of the Company to the amendment in the shares' register of the Company.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately one thousand seven hundred
Euros (EUR 1,700.-).
There being no further business, the meeting is terminated.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded
in French, followed by an English version and in case of discrepancies between the French and the English text, the French
version will be binding.
WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the Meeting, the members of the bureau of the Meeting, all of whom are known
to the notary by their names, surnames, civil status and residences, signed together with us, the notary, the present
original deed.
Signé: Zimmer, Nezar, Drauth, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 10 septembre 2014. Relation: LAC/2014/42132. Reçu soixante-quinze euros
(75,00 €).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène Thill.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Luxembourg, le 12 septembre 2014.
Référence de publication: 2014143069/158.
(140162292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2014.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
147120
Bluere Investment Limited, S.à r.l.
Capula ESS Lux 1 S.à r.l.
Censi SP S.à r.l.
Crosslink Investment Consulting S.A.
Fibalux S.A.
France Property Holdco IV S.à r.l.
France Property Holdco S.à r.l.
Gallina Invest S.à r.l.
GaveKal Multi-Strategy Fund SIF SICAV S.A.
Glenda 1980 S.A.
Glenmoore S.à r.l.
Guardian Segur S.A.
Harbour HoldCo S.à r.l.
Helarb Investments Partners (SCA) SICAR
Honeywell Holding Europe Limited LLC
Huggy-Store Hoscheid Dickt Sàrl
LDV Management III S.à r.l.
LDV Management S.à r.l.
Lewington S.à r.l.
Lux-Fiduciaire S.à r.l.
Mainoria SICAV - SIF
Mapitop S.à r.l.
Neightilus S.à r.l.
Norwich S.à r.l.
Olympia Management S.à r.l.
Opus Securities S.A.
Oystercatcher Luxco 1 S.à r.l.
Panlip S.A., SPF
Pergam Properties 2 S.C.A.
Pergam Properties 2 S.C.A.
Petroleum Marine Services
PLF Licensing S.à r.l.
PO Invest 1 S.A.
Portofino Properties
Property S.A.
Ravago S.A.
Saint-Georges
Secure S.A.
Sinequanon Health Care SA
Société Immobilière auf dem Butterbrill
Société Luxembourgeoise de Transports S.A.
Soparlux International S.A.
Stark PSM Technology S.à r.l.
STEPEC PROMOTION Luxembourg S.àr.l.
Tescara S.A.
Timken Luxembourg Holdings Sàrl
Transport Da Conceicao Martins S.à r.l.
United Bargain Société de Participations S.A.
Universal Premium Trading
V.D.T.I. S.à r.l.
Zimmer & Partners S.A.