logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 3063

22 octobre 2014

SOMMAIRE

Audit & Maintenance S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

146978

Bayerische Architektenversorgung & Co.

S.N.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147008

Black & Decker International Finance 3 Li-

mited  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146989

CCP III DK Germany S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

147008

Gsmp VI Offshore International Holdings

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146999

Holly Tree Immobilier S.A.  . . . . . . . . . . . . .

146978

Holly Tree Investments S.A.  . . . . . . . . . . . .

146978

International Bénin Group Corporation

Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146978

LFC Invest S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147024

Paris Luxembourg Participations S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147024

Sablon International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

146980

Salon Christiane S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

146983

Saona S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146988

SEB 10 - SICAV - FIS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146980

SEB 10 - SICAV - FIS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146988

Segepa S.A. SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146981

SES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146983

SHCO 17 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146985

Ships & Ferries International S.A.  . . . . . . .

146981

Siland Invest S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146979

Simpat S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146979

Société Anonyme pour la Recherche d'In-

vestissements S.A.P.R.I. S.A. société de
gestion de patrimoine familial . . . . . . . . . .

146980

Société Anonyme pour la Recherche d'In-

vestissements S.A.P.R.I. S.A. société de
gestion de patrimoine familial . . . . . . . . . .

146982

Société Immobilière DM S.àr.l.  . . . . . . . . . .

146983

Solfin International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

146984

Sparinvest Holdings SE  . . . . . . . . . . . . . . . . .

146979

Sparinvest Holdings SE  . . . . . . . . . . . . . . . . .

146986

Spinnaker HoldCo S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

146982

Squirrel AcquiCo I S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

146984

Stadsfeestzaal Lux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

146982

Stena Carron Lux 2 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

146979

Stena Drillmax Lux 2 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

146979

Sungem Serfinco S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

146982

Systexan S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146987

Tarmac Investments (China)  . . . . . . . . . . . .

146978

Tasco International S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

146985

TDL Financing Luxembourg Sàrl  . . . . . . . .

146981

Tedev  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146983

Tele Columbus Management S.à r.l.  . . . . .

146984

Terryglas S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146984

Thibauting S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146986

Threestones Capital Management S.A.  . .

146986

Toole S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146991

Trans IV (Luxembourg) Properties S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146980

TRG SOF Holdings IV S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

146987

Triton Masterluxco 3 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

146988

Triton Masterluxco 4 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

146985

T. Rowe Price (Luxembourg) Management

Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147024

Turf Développement  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146985

UK Logistics Topco I S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

146986

Vesuvia S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

146987

Victus Holdings (Europe) S.à r.l.  . . . . . . . . .

146987

Windfall Lux S.A. SICAV-SIF . . . . . . . . . . . .

146988

146977

L

U X E M B O U R G

Holly Tree Immobilier S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 1, rue Pletzer.

R.C.S. Luxembourg B 118.578.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 11 septembre 2014.

Référence de publication: 2014142181/10.
(140161377) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2014.

Holly Tree Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 1, rue Pletzer.

R.C.S. Luxembourg B 105.637.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 11 septembre 2014.

Référence de publication: 2014142182/10.
(140161324) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2014.

Audit & Maintenance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8510 Rédange-sur-Attert, 63, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 160.588.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2014144583/11.
(140164540) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2014.

International Bénin Group Corporation Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 9, route des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 189.816.

INTERNATIONAL BENIN GROUP CORPORATION LUXEMBOURG S.A
9 route des trois cantons
L-8399 Windhof

Luxembourg, le 16 Septembre 2014.

Signature.

Référence de publication: 2014144561/11.
(140164061) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2014.

Tarmac Investments (China), Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 96.287.

Les comptes annuels de la société au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2014144471/12.
(140163708) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2014.

146978

L

U X E M B O U R G

Stena Carron Lux 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 172.773.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014144420/9.
(140164040) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2014.

Stena Drillmax Lux 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 176.686.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014144422/9.
(140164156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2014.

Siland Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 98.182.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014144449/10.
(140163954) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2014.

Simpat S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1320 Luxembourg, 70, rue de Cessange.

R.C.S. Luxembourg B 129.328.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014144451/10.
(140164059) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2014.

Sparinvest Holdings SE, Société Européenne.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 164.834.

In der ordentlichen Generalversammlung vom 12. April 2012 wurde beschlossen, Herrn Jan Pedersen, geboren am 27.

Februar 1964 in Esbjerg (Dänemark) mit Privatadresse in Skovbakkevej 95, DK-8800 Viborg, Dänemark, als Verwal-
tungsratsmitglied bis zum Ablauf der ordentlichen Generalversammlung, die im Jahre 2013 abgehalten wurde, zu ernennen.
Gleichzeitig ist Herr Vagn Thomsen Raun als Verwaltungsratsmitglied zurückgetreten.

Dem Verwaltungsrat wurde in seiner Sitzung vom 29. November 2012 der Rücktritt des ehemaligen Verwaltungs-

ratsmitglieds Frank Alex Kristensen mitgeteilt. Es wurde kein Nachfolger ernannt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 15. September 2014.

SPARINVEST HOLDINGS SE

Référence de publication: 2014145133/16.
(140164634) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2014.

146979

L

U X E M B O U R G

Sablon International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.

R.C.S. Luxembourg B 121.008.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014145143/9.
(140164904) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2014.

Société Anonyme pour la Recherche d'Investissements S.A.P.R.I. S.A. société de gestion de patrimoine

familial, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2543 Luxembourg, 30, Dernier Sol.

R.C.S. Luxembourg B 15.550.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014145129/11.
(140165042) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2014.

Trans IV (Luxembourg) Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 94.464.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 septembre 2014.

Jacob Mudde
<i>Gérant

Référence de publication: 2014145175/13.
(140164641) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2014.

SEB 10 - SICAV - FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen.

R.C.S. Luxembourg B 133.426.

EXTRAIT

Monsieur Ralf Ferner a démissionné de son poste d'administrateur avec effet au 16 septembre 2014.
L'assemblée générale annuelle des actionnaires a procédé en date du 16 septembre 2014 aux nominations des admi-

nistrateurs suivants dont le mandat prendra fin à l'issue de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires en
2015:

Mr Peter Kubicki avec adresse professionnelle à L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen, président du conseil d'adminis-

tration

Monsieur Matthias Ewald avec adresse professionnelle à L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen
Monsieur Tobias Hjelm avec adresse professionnelle à S-106 40 Stockholm, Sveavägen, 8.
A été nommé réviseur d'entreprise agréé pour un mandat prenant fin à l'assemblée générale annuelle des actionnaires

en 2015:

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014145149/21.
(140165268) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2014.

146980

L

U X E M B O U R G

Ships &amp; Ferries International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 86.578.

Au terme du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 19 mars 2014, il a été décidé:
L'assemblée décide de renouveler le mandat des administrateurs jusqu'à l'assemblée qui se tiendra en l'année 2017.
Les administrateurs sont:
- Monsieur Kladias Georgios, Administrateur de classe «B» résidant 2, lassonos Street, GR-18537 Piraeus
- Monsieur Kefalonitis Theodoros, Président et administrateur de classe «B» résidant 2, Iassonos Street, GR-18537

Piraeus

- Monsieur Tomasos Costantino, Administrateur de classe «A» résidant 57 Artemonos, GR-18537 Piraeus
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2014145156/16.
(140164775) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2014.

TDL Financing Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 5.240.000,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 160.656.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions écrites prises par l'associé unique de la Société en date du 15 septembre 2014 que:
- La démission de Madame Inga ASTASHOVA, gérant de catégorie B de la Société, a été acceptée, avec effet au 27

août 2014;

- Madame Inna HÖRNER, née le 25 octobre 1980 à Karaganda, Kazakhstan et résidant professionnellement au 16,

avenue Pasteur L-2310 Luxembourg, a été nommé en tant que gérant de catégorie B de la Société, avec effet au 27 août
2014 et ce, pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 septembre 2014.

Référence de publication: 2014145185/17.
(140165217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2014.

Segepa S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 170.947.

<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration tenu en date du 16 septembre 2014

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 16 septembre 2014 que:
- Le siège social de la société est transféré du 3-7 rue Schiller L-2519 Luxembourg au 50 rue Charles Martel L-2134

Luxembourg, avec effet au 1 

er

 septembre 2014.

- L'administrateur M. Claude ZIMMER est domicilié professionnellement au 50 rue Charles Martel L-2134 Luxembourg

et ce, avec effet au 1 

er

 septembre 2014.

- L'administrateur M. Roland WEBER est domicilié professionnellement au 50 rue Charles Martel L-2134 Luxembourg

et ce, avec effet au 1 

er

 septembre 2014.

- La société ZIMMER &amp; PARTNERS S.A. commissaire aux comptes, société enregistrée auprès du Registre de Com-

merce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B151.507 est transféré du 3-7 rue Schiller L-2519 au 50, rue Charles
Martel, L-2134 Luxembourg et ce, avec effet au 1 

er

 Septembre 2014.

Extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014145151/21.
(140165173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2014.

146981

L

U X E M B O U R G

Société Anonyme pour la Recherche d'Investissements S.A.P.R.I. S.A. société de gestion de patrimoine

familial, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2543 Luxembourg, 30, Dernier Sol.

R.C.S. Luxembourg B 15.550.

Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014145130/11.
(140165043) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2014.

Sungem Serfinco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 142.456.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014145166/9.
(140164931) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2014.

Stadsfeestzaal Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 123.434.

<i>Extrait des Résolutions de l'associé unique du 28 July 2014

L'associé unique de Stadsfeestzaal Lux S.à r.l. (la "Société"), a décidé comme suit:
- d'accepter la démission de Luxembourg Corporation Company S.A, et ce avec effet au 28 Juillet 2014;

Luxembourg, le 17 September 2014.

Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2014145138/14.
(140165131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2014.

Spinnaker HoldCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2C, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 189.065.

EXTRAIT

Suivant un contrat de transfert de parts sociales en date du 15 septembre 2014, Triton Masterluxco 4 S.à r.l. une

société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de EUR 12.500,03,
avec siège social au 2C, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 177725, a cédé la totalité des parts sociales qu'elle détient dans la Société à
Triton IV LuxCo No. 11 S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg,
avec siège social au 2C, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 190.167.

En conséquence, les parts sociales de la Société sont à présent détenues comme suit:

Triton IV LuxCo No. 11 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.250.000

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Spinnaker HoldCo S.à r.l.

Référence de publication: 2014145136/20.
(140164851) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2014.

146982

L

U X E M B O U R G

Salon Christiane S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4743 Pétange, 19, rue Aloyse Kayser.

R.C.S. Luxembourg B 149.371.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014145144/9.
(140165290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2014.

Tedev, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 100.000,00.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 173.197.

EXTRAIT

L'un des gérants et associés de la société, à savoir Monsieur Bernard TEILLAUD, a désormais comme adresse;
- Villa 57, Domaine Royal Palm, Km 12, Route Amizmiz, CR TAMESLOHT, Maroc.

Luxembourg, le 17 septembre 2014.

<i>Pour TEDEV
Société à responsabilité limitée

Référence de publication: 2014145186/14.
(140164900) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2014.

Société Immobilière DM S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3895 Foetz, 10, rue de l'Avenir.

R.C.S. Luxembourg B 135.787.

L'assemblée générale a décidé de révoquer avec effet immédiat, M. Giacometti Giancarlo, de son poste de gérant.
L'assemblée générale a décidé de nommer, pour une durée illimitée à compter du 1 

er

 septembre 2014, M. Thierry

Giacometti, résident professionnellement 10, rue de l'Avenir - L3895 Foetz au poste de Gérant.

L'assemblée générale a décidé que le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour engager la société, en toutes cir-

constances, par sa seule signature.

Foetz, le 02 septembre 2014.

<i>Pour la société
L'associé unique

Référence de publication: 2014145161/15.
(140165153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2014.

SES, Société Anonyme.

Siège social: L-6815 Betzdorf, Château de Betzdorf.

R.C.S. Luxembourg B 81.267.

EXTRAIT

<i>Conseil d'Administration

Mme Miriam Meckel a donné sa démission en tant que Administrateur du Conseil d'Administration de SES avec effet

au 30 juin 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Betzdorf, le 17 septembre 2014.

<i>Pour la Société
Pierre Margue
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014145152/16.
(140164698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2014.

146983

L

U X E M B O U R G

Squirrel AcquiCo I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 173.485.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014145137/10.
(140165233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2014.

Solfin International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.

R.C.S. Luxembourg B 84.036.

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire du 18 juin 2014 que dorénavant, Madame Valérie WESQUY née à Mont-

Saint-Martin (France) le 6 mars 1968, demeurant professionnellement 19 Boulevard Grande-duchesse Charlotte à L-1331
Luxembourg, sera inscrite sous le nom de Madame Valérie RAVIZZA.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2014145162/12.
(140164676) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2014.

Tele Columbus Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 155.327.

Par résolutions signées en date du 10 septembre 2014, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Nomination de Christian Boekhorst, avec adresse au 123, Doria Road, SW6 4UG Londres, Royaume-Uni au mandat

de gérant de classe A, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée;

2. Acceptation de la démission de Ronny Verhelst, avec adresse au 15, Rüsternallee, 14050 Berlin, Allemagne, de son

mandat gérant de classe A, avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 septembre 2014.

Référence de publication: 2014145169/14.
(140164962) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2014.

Terryglas S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 162.790.

Il résulte du contrat de transfert signé en date du 13 Juin 2014, que les parts sociales de la société, de EUR 1,- chacune,

sont désormais réparties comme suit:

Désignation des associés

Nombre

de parts

Reese S. à r. l.
42-44, Avenue de la Gare
L-1610 Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.500

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.500

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 17 septembre 2014.

Référence de publication: 2014145170/18.
(140165193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2014.

146984

L

U X E M B O U R G

SHCO 17 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 5, rue des Capucins.

R.C.S. Luxembourg B 154.693.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014145155/9.
(140164601) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2014.

Turf Développement, Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 101.966.

EXTRAIT

Il est porté à la connaissance des tiers le changement de l'adresse professionnelle de Monsieur Julien Billot, adminis-

trateur A de la société au 345, chemin Strathcona, Mont-Royal, H3R 1E9, province de Québec, Canada.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014145177/11.
(140164810) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2014.

Tasco International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 19.634.500,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 133.309.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait sincère et conforme
TASCO INTERNATIONAL S. à r.l.
Signature

Référence de publication: 2014145178/13.
(140165297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2014.

Triton Masterluxco 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,02.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2C, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 177.725.

EXTRAIT

Les associés de la Société, par résolutions écrites datées du 24 juin 2014, ont décidé de transférer le siège social de

la Société au 2C, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, avec effet au 15 septembre 2014.

Les associés de la Société ont également transféré leur siège social au 2C, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg,

avec effet au 15 septembre 201 4.

L'associé Triton IV No. 3 S.à r.l. a changé sa dénomination en Rice TopCo S.à r.l.
Les adresses professionnelles des gérants Heiko Dimmerling, Thomas Sonnenberg, Michiel Kramer et Antonis Tzanetis

ont également changés. Lesdits gérants résident dorénavant professionnellement au 2C, rue Albert Borschette, L-1246
Luxembourg.

Le gérant Mats Eklund a également transféré son adresse professionnelle au 9 South Street, 3 

ème

 étage, Londres, W1K

2XA, Royaume-Uni.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour TRITON MASTERLUXCO 4 S.à r.l.

Référence de publication: 2014145194/21.
(140164595) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2014.

146985

L

U X E M B O U R G

Threestones Capital Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.

R.C.S. Luxembourg B 146.773.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014145172/9.
(140164581) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2014.

Thibauting S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 178.016.

Les comptes au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Thibauting S.A.

Référence de publication: 2014145171/10.
(140165208) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2014.

Sparinvest Holdings SE, Société Européenne.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 164.834.

<i>Auszug aus der ordentlichen Generalversammlung vom 15. April 2014

Die jeweiligen Mandate der Verwaltungsratsmitglieder Klaus Skjødt, Niels Fessel, Bjarne Toftlund, Peter Bache Vognb-

jerg, Vagn Hansen, Ivan Christiansen, Jan Pedersen, Per Noesgaard und Henrik Lind-Grønbæk wurden bis zum Ablauf der
ordentlichen Generalversammlung, die im Jahre 2015 abgehalten wird, verlängert.

Das Mandat des Wirtschaftsprüfers Ernst &amp; Young, 7, Rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, wurde verlängert und

wird mit Ablauf der ordentlichen Generalversammlung, die im Jahre 2015 stattfindet, ablaufen.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 15. September 2014.

SPARINVEST HOLDINGS SE

Référence de publication: 2014145134/16.
(140164634) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2014.

UK Logistics Topco I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 15.000,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 166.408.

Il résulte d'un contrat de contribution et transfert de parts, signé en date du 16 janvier 2014, que l'associé de la Société,

BRE/Europe 6Q S.à r.l. a transféré la totalité de 750 parts sociales qu'il détenait dans la Société de la manière suivante:

(1) Logicor Europe Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois du Luxembourg,

ayant son siège social à l'adresse suivante: 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453, Luxembourg, et immatriculée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 177.675, 750 parts sociales;

Les parts de la Société sont désormais réparties comme suit:

1. Logicor Europe Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750 parts sociales

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 septembre 2014.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2014145202/19.
(140164671) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2014.

146986

L

U X E M B O U R G

Systexan S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 61.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 173.866.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 septembre 2014.

Référence de publication: 2014145142/10.
(140164846) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2014.

TRG SOF Holdings IV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 5.734.000,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 116.206.

En date du 15 septembre 2014, l'associé unique a décidé d'accepter la démission de Monsieur Jonathan Taylor Marom

en qualité de gérant de TRG SOF Holdings IV S.à r.l. avec effet au 15 septembre 2014.

Luxembourg, le 17 septembre 2014.

TRG SOF Holdings IV S.à r.l.

Référence de publication: 2014145191/12.
(140164692) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2014.

Vesuvia S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 131.268.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 16 septembre 2014 a nommé comme nouvel administrateur

de la société:

- Madame Nicole Thommes, Arlon (Belgique) le 28 octobre 1961, domicilié professionnellement au 18 rue de l'Eau,

L-1449 Luxembourg;

en remplacement de Monsieur Sébastien Gravière.
Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2017.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2014145210/15.
(140164890) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2014.

Victus Holdings (Europe) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 62.000,00.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 178.309.

<i>Extrait des résolutions de l'associé unique de la Société

Il résulte des décisions de l'associé unique de la Société en date du 04 septembre 2014, qui ont acceptées:
- la démission de Monsieur Langford Clifford de son poste de gérante de la Société, avec effet au 31 août 2014.
- le changement d'adresse de Mr Gunter Gommes, gérant de la Société. Il réside désormais au, Les Ormes Leisure

Village, Le mont a la Brune, St Brelade, JE3 8FL, Jersey, Royaume-Uni.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 septembre 2014.

Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2014145206/17.
(140164898) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2014.

146987

L

U X E M B O U R G

Saona S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 159.924.

OBC by P. Thielen domiciliation, ayant son siège social à L-1420 Luxembourg, avenue Gaston Diderich, 5-11, dénonce

en date du 10 septembre 2014 le contrat de domiciliation qui la lie à la société anonyme SAONA S.A., inscrite au R.C.S.
Luxembourg sous le numéro B159924, ainsi que le siège social fixé à L-1420 Luxembourg, avenue Gaston Diderich, 5-11.

Luxembourg, le 10 septembre 2014.

Référence de publication: 2014145146/10.
(140165287) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2014.

SEB 10 - SICAV - FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen.

R.C.S. Luxembourg B 133.426.

Le rapport annuel au 31 mars 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014145150/10.
(140165333) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2014.

Windfall Lux S.A. SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement

Spécialisé.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 135.720.

<i>Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale statutaire du 15 septembre 2014

KPMG Luxembourg S.à r.l. est réélu en qualité de réviseur d'entreprises pour un nouveau terme d'un an, se terminant

à l'assemblée générale statutaire de 2015.

Extrait certifié sincère et conforme
<i>Pour WINDFALL LUX S.A. SICAV-SIF
KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.

Référence de publication: 2014145224/14.
(140165126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2014.

Triton Masterluxco 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,23.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2C, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 143.926.

EXTRAIT

Les associés de la Société, par résolutions écrites datées du 24 juin 2014, ont décidé de transférer le siège social de

la Société au 2C, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, avec effet au 15 septembre 2014.

Les associés de la Société ont tous également transféré leur siège social au 2C, rue Albert Borschette, L-1246 Lu-

xembourg, avec effet au 15 septembre 2014.

Les adresses professionnelles des gérants Heiko Dimmerling, Thomas Sonnenberg, Michiel Kramer et Antonis Tzanetis

ont également changés. Lesdits gérants résident dorénavant professionnellement au 2C, rue Albert Borschette, L-1246
Luxembourg.

Le gérant Mats Eklund a également transféré son adresse professionnelle au 9 South Street, 3 

ème

 étage, Londres, W1K

2XA, Royaume-Uni.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour TRITON MASTERLUXCO 3 S.à r.l.

Référence de publication: 2014145193/20.
(140164554) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2014.

146988

L

U X E M B O U R G

Black &amp; Decker International Finance 3 Limited, Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 50.002,00.

Siège de direction effectif: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 150.522.

In the year two thousand and fourteen, on the fifth day of September.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Black &amp; Decker International Finance 3

Limited, a Luxembourg and Irish private limited liability company (société à responsabilité limitée) having its registered
office at 14-15 Parliament Street, Castleriver House, Dublin, 2, Ireland and its seat of effective management at 40, avenue
Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of USD 50,002 and registered with
the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 150522 and registered with the Companies Registration
Office of Ireland under file number 391397 (the Company). The articles of association of the Company (the Articles)
were amended for the last time on 4 December 2012 pursuant to a deed of Maître Francis Kesseler, notary then residing
in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 394
dated 18 February 2013.

There appeared:

Black &amp; Decker Manufacturing, Distribution, and Global Purchasing Holdings LP, a Cayman Islands limited partnership,

with registered office at c/o Appleby Trust (Cayman) Ltd., Clifton House, 75 Fort Street, George Town, Grand Cayman,
registered with the Cayman Island Registrar under number 36905, being the holder of all the 50,000 ordinary shares of
the Company having a nominal value of USD 1 each, acting through its general partner (gérant commandité), being SBD
MDGP Partnership Holdings S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) existing under the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 40 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, with a share capital of USD 20,000 and registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) under number B 172626 (the Shareholder),

hereby represented by Maître Pol Theisen, avocat, professionally residing at 33, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxem-

bourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

Said proxy, after having been initialled ne varietur by the proxyholder of the Shareholder and the undersigned notary,

shall remain attached to the present deed, and be submitted with this deed to the registration authorities.

The Shareholder, represented as stated above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. that the 25,000 (twenty-five thousand) shares of the Company, having a nominal value of EUR 1 (one Euro) each,

representing the entirety of the share capital of the Company, are duly represented at the Meeting;

II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:
(1) Waiver of the convening notices;
(2) Approval of the change of the address of the place of effective management of the Company;
(3) Amendment of article 1(b) of the articles of association of the Company in order to reflect the change of the

address of the registered office of the Company under item (2) above; and

(4) Miscellaneous.
The Meeting has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The entirety of the share capital of the Company being represented at the present Meeting, the Meeting waives the

convening notice, the Shareholder represented considering itself as duly convened and declaring having perfect knowledge
of the agenda which has been communicated to it in advance of the Meeting.

<i>Second resolution

The Meeting resolves to transfer the seat of effective management of the Company from its current address being 40,

avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg to 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, Grand Duchy
of Luxembourg.

<i>Third resolution

The Meeting resolves to amend the first paragraph of article 1(b) of the Articles so that it shall henceforth read as

follows:

146989

L

U X E M B O U R G

“ 1. Company.
(b) The Company’s registered office is situated at Castle River House, 14-15 Parliament Street, Dublin 2, Ireland. The

effective management seat of the Company is situated in Strassen, Grand Duchy of Luxembourg and may be transferred
to any place within the boundaries of the municipality of Strassen by a resolution of the board of Directors.”

<i>Fourth resolution

The Meeting resolves to authorise and empower with power of substitution any manager of the Company, each acting

individually under his/her sole signature, in the name and on behalf of the Company to see to and to accomplish any
necessary formalities with the relevant Luxembourg authorities in relation to the filing of the transfer of the registered
office  with  the  Luxembourg  Trade  and  Companies  Register  and  generally  to  perform  any  other  action  that  may  be
necessary or useful in relation with such filing.

<i>Estimate of costs

The amount of expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the

Company as a result of the present deed is estimated to be approximately EUR 1,400.-

The undersigned notary, who understands and speaks English, stated herewith that on request of proxyholder of the

Shareholder, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the proxyholder of
the Shareholder, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

Whereof, the present notarial deed was drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the Shareholder, the said proxyholder signed together with

us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède.

L'an deux mille quatorze, le cinquième jour du mois de septembre.
Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg au Grand-Duché de Luxembourg.

S'est tenue

l’assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) de l’associé unique de Black &amp; Decker International Finance 3 Li-

mited, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 14-15 Parliament Street,
Castleriver House, Dublin, 2, Irlande et son lieu de l’administration central au 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de 50.002 USD (cinquante mille et deux dollars américains) et
immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 150522 et auprès du
Companies Registration Office of Irelande sous le numéro 391397 (la Société). Les statuts de la Société (les Statuts) ont
été modifiés pour la dernière fois le 4 décembre 2012 en vertu d’un acte de Maître Francis Kesseler, notaire ayant résidé
à l’époque à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N
° 394 daté du 18 février 2013.

A comparu:

Black &amp; Decker Manufacturing, distribution, and Global Purchasing Holdings LP, un Cayman Islands limited partnership,

ayant son siège social au c/o Appleby Trust (Cayman) Ltd., Clifton House, 75 Fort Street, George Town, Grand Cayman,
immatriculée auprès du Cayman Island Registrar sous le numéro 36905, étant titulaire de l’intégralité des 50.000 parts
sociales ordinaires de la Société ayant chacune une valeur nominale de 1 USD, agissant par son gérant commandité, SBD
MDGP Partnership Holdings S.à.r.l., une société à responsabilité limitée de droit, ayant son siège social à 40, Avenue
Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de 20.000 USD et immatriculée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 172626 (l’Associé)

ci-après représenté par Maître Pol Theisen, avocat, résidant professionnellement au 33, Avenue J.-F. Kennedy, L-1855

Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une procuration accordée sous seing privé.

Ladite  procuration,  après avoir été paraphée  ne  varietur  par le mandataire  de l’Associé  Unique  et par le  notaire

instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec ce dernier aux formalités de l’enregistrement.

L’Associé, représenté tel qu'indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire de prendre acte de ce qui suit:
I. que 25.000 (vingt-cinq mille) parts sociales ordinaires de la Société, ayant chacune une valeur nominale de 1 EUR

(un Euro), représentant l’intégralité du capital social de la Société sont dûment représentées à l’Assemblée; et

II. que l’ordre de jour de l’Assemblée est libellé comme suit:
(1) Renonciation aux formalités de convocation;
(2) Décision de transférer le lieu de la gestion effective de la Société;
(3) Modification de l’article 1(b) des Statuts afin de refléter le changement du siège de direction effective de la Société

sous (2) ci-dessus; et

(4) Divers.
L’Assemblée a pris les résolutions suivantes:

146990

L

U X E M B O U R G

<i>Première résolution

L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à la présente Assemblée, l’Assemblée décide de renoncer

aux formalités de convocation, les Associés représentés se considérant comme dûment convoqués et déclarant avoir une
parfaite connaissance de l’ordre du jour qui lui a été communiqué par avance.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de transférer le lieu de la gestion effective de son adresse actuelle étant 40, Avenue Monterey,

L-2163 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, Grand-Duché de Luxembourg.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l’article 1(b) des Statuts de sorte qu'il aura désormais la

teneur suivante:

« 1. Société.
(b) Le siège statutaire de la Société est sis à Castle River House, 14-15 Parliament Street, Dublin 2, Irlande. Le lieu de

la gestion effective de la Société est situé dans la commune de Strassen, Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra être
transféré dans les limites de la commune de Strassen par une décision du Conseil de Gérance.»

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée décide d'accorder pouvoir et autorisation avec pouvoir de substitution à tout gérant de la Société agissant

individuellement et sous sa seule signature, au nom et pour le compte de la Société afin de procéder à toutes les formalités
nécessaires auprès des autorités luxembourgeoises compétentes relatives au dépôt et à l’enregistrement du transfert du
siège social de la Société auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et plus généralement afin de
procéder à toutes démarches nécessaires ou utiles en relation avec lesdites formalités.

<i>Estimation des frais

Le montant des dépenses, frais, émoluments et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la

Société en conséquence du présent acte sont estimés approximativement à EUR 1.400.-Le notaire soussigné qui comprend
et parle anglais, déclare qu'à la requête du mandataire de l’Associé, le présent acte a été établi en anglais, suivi d'une
version française. A la requête de ce même mandataire, et en cas de divergences entre les versions anglaise et française,
la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite au mandataire de l’Associé, ce dernier a signé ensemble avec le notaire, l’original du présent acte.
Signé: P. THEISEN et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 8 septembre 2014. Relation: LAC/2014/41651. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 11 septembre 2014.

Référence de publication: 2014141949/142.
(140161362) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2014.

Toole S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 190.090.

STATUTES

In the year two thousand and fourteen, on the ninth day of September,
Before the undersigned Maître Joseph ELVINGER, Civil Law Notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Lu-

xembourg.

THERE APPEARED

MELAMPYRE SA, a “Société Anonyme”” having its registered office at 16, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Lu-

xembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under section B number 160196,

here represented by Laurence Diettert, private employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy

given privately to her on 5 September 2014.

146991

L

U X E M B O U R G

The said proxy, initialled ne varietur by the proxy-holder of the appearing party and the notary, will remain annexed

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, represented as hereabove stated, has requested the officiating notary to document the following

articles of incorporation of a Société à responsabilité limitée, private limited liability company (the "Articles"), it deems
to incorporate as shareholder or with any person or entity which may become shareholder of this company in the future.

Art. 1. Name. There is hereby formed a Société à responsabilité limitée, private limited liability company under the

name “TOOLE S.à r.l.” (the "Company") governed by the present Articles of incorporation and by current Luxembourg
laws, and in particular the law of August 10 

th

 , 1915 on commercial companies (the "Law"), and the law of September

18 

th

 , 1933 and of December 28 

th

 , 1992 on Sociétés à responsabilité limitée.

Art. 2. Object. The purpose of the Company shall be the acquisition of ownership interests, in Luxembourg or abroad,

in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such ownership interests. The Company
may in particular acquire by way of subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and
securities of whatever nature, including bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more
generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in
the creation, development and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and mana-
gement of a portfolio of patents and other intellectual property rights.

The Company may act as an investment holding company and co-ordinate the business of any corporate bodies in

which it is for the time being directly or indirectly interested.

The Company may borrow in any way form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt or other equity securities. The Company may lend funds, including
the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other
companies which form part of the same group of companies as the Company. It may also give guarantees and grant security
interests in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or
any other companies, which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may further mortgage, pledge, hypothecate, transfer or otherwise encumber all or some of its assets.

The Company may generally employ any techniques and utilise any instruments relating to its investments for the purpose
of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit risk,
currency fluctuations risk, interest rate fluctuation risk and other risks.

The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to

real estate or movable property.

The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions, which may be or

are conducive to the above-mentioned paragraphs of this Article 2.

Art. 3. Registered office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-

bourg.

The registered office of the Company may be transferred within the municipality of Luxembourg by decision of the

board of managers.

The registered office of the Company may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg or

abroad by means of a resolution of an extraordinary general meeting of shareholder(s) deliberating in the manner provided
by the Law.

The Company may have offices and branches (whether or not a permanent establishment) both in Luxembourg and

abroad.

In the event that the board of managers should determine that extraordinary political, economic or social developments

have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
board of managers of the Company.

Art. 4. Duration. The Company is established for an unlimited duration.
The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of any

shareholder.

Art. 5. Capital. The capital of the Company is set at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) represented

by one hundred and twenty five (125) shares with a nominal value of one hundred euros (EUR 100.-) each.

The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholder

(s) adopted in the same manner required for amendment of the Articles.

Art. 6. Shares. Each share of the Company confers an identical voting right and each shareholder has voting rights

commensurate to his shareholding.

146992

L

U X E M B O U R G

The shares are freely transferable among the shareholders.
Shares may not be transferred to non-shareholders unless shareholders representing at least three-quarter of the

share capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Furthermore it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the Law.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admits only one owner per share.
The Company shall have power to redeem its own shares. Such redemption shall be carried out by a unanimous

resolution of an extraordinary general meeting of the shareholder(s), representing the entirety of the subscribed capital
of the Company.

Art. 7. Management. The Company is managed by one or several managers. In case of plurality of managers, the

managers constitute a board of managers..

The manager(s) need not be shareholders of the Company.
The managers shall be appointed by a resolution of the general meeting of shareholders taken by simple majority of

the votes cast, or, in case of sole shareholder, by decision of the sole shareholder which determines their powers, their
remuneration and the duration of their mandate. The general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the
case may be) may, at any time and ad nutum, remove and replace any manager.

All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of shareholders or to the sole

shareholder (as the case may be) fall within the competence of the board of managers.

Art. 8. Representation. The signature of the sole manager shall bind the Company. In the case of plurality of managers,

the Company shall be bound at any time by the joint signature of two managers for any engagement which exceed EUR
10,000.-.

A manager may delegate or sub-delegate his signature to another manager. Each delegation must be expressly notified

by the principal to the delegated manager. This notification may be sent by mail, e-mail or fax.

The board of managers may from time to time sub-delegate its powers for specific tasks to one or several ad hoc agent

(s) who need not be shareholder(s) or manager(s) of the Company.

The board of managers will determine the powers, duties and remuneration (if any) of its agent(s), the duration of the

period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.

Art. 9. Procedure. In case of plurality of managers, the board of managers shall choose from among its members a

chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes
of the meetings of the board of managers.

The board of managers shall meet when convened by one manager.
Notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers in advance of the time set for such

meeting except in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the minute of the meeting.

Any such notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be transacted.
Notice can be given to each manager orally, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means.
The notice may be waived by the consent, in writing or by fax or any other electronic means of communication of

each manager.

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.
The board of managers may only validly deliberate if at least half of its members are present or represented.
Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by fax or any other electronic means of

communication, another manager as his proxy. A manager may represent more than one manager.

Any and all managers may participate in a meeting of the board of managers by phone, videoconference, or electronic

means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time. Such participation in a meeting
is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the managers.

Except as otherwise required by these Articles, decisions of the board are adopted by at least a simple majority of the

managers present or represented.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at a meeting

of the board of managers.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated in writing by circular way, transmitted

by ordinary mail, electronic mail or fax, or by phone, teleconferencing or and other suitable telecommunication means.

A written resolution can be documented in a single document or in several separate documents having the same

content.

The deliberations of the board of managers shall be recorded in the minutes, which have to be signed by the chairman.

Art. 10. Liability of the managers. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning

the commitments regularly taken by him in the name of the Company; as a representative of the Company he is only
responsible for the execution of his mandate.

146993

L

U X E M B O U R G

Art. 11. General meetings of shareholders. General meetings of shareholders are convened by the board of managers,

failing which by shareholders representing more than half of the capital of the Company.

Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be made pursuant to the Law and is

sent to each shareholder by mail and / or electronically and shall specify the time and place of the meeting.

If all shareholders are present or represented at the general meeting and state that they have been duly informed on

the agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice.

Any shareholder may act at any general meeting by appointing in writing another person who need not be shareholder.
Resolutions at the meetings of shareholders are validly taken in so far as they are adopted by shareholders representing

more than half of the share capital of the Company.

However, resolutions to amend the Articles shall only be taken by an extraordinary general meeting of shareholder

(s) at a majority in number of shareholders representing at least three-quarters of the share capital of the Company.

A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the provisions of the Law.
As a consequence thereof, the sole shareholder takes all decisions that exceed the powers of the board of managers.

Art. 12. Annual general meeting. An annual general meeting of shareholders approving the annual accounts shall be

held annually, at the latest within six months after the close of the accounting year at the registered office of the Company
or at such other place as may be specified in the notice of the meeting.

Art. 13. Financial year. The Company's financial year begins on the 1 

st

 January and closes on the 31 

st

 December.

Art. 14. Annual accounts. At the end of each financial year, the board of managers will draw up the annual accounts

of the Company, which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities.

Each shareholder may inspect annual accounts at the registered office of the Company.

Art. 15. Supervision of the company. If the shareholders number exceeds twenty-five, the supervision of the Company

shall be entrusted to one or more statutory auditor (commissaire), who may or may not be shareholder(s).

Each statutory auditor shall serve for a term ending on the date of the annual general meeting of shareholders following

appointment.

At the end of this period, the statutory auditor(s) can be renewed in its/their function by a new resolution of the

general meeting of shareholders.

Where the thresholds of article 35 of the Law of 19 December 2002 on the register of commerce and companies and

accounting and annual accounts, as amended, are met, the Company shall have its annual accounts audited by one or
more qualified auditor (réviseurs d'entreprises) appointed by the general meeting of shareholders or the sole shareholder
(as the case may be) amongst the members of the Institut des réviseurs d'entreprises.

Notwithstanding the thresholds above mentioned, at any time, one or more qualified auditor may be appointed by

resolution of the general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) that shall decide the
terms and conditions of his/their mandate.

Art. 16. Allocation of profits. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs,

amortizations, charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year, five percent (5%) of the net profit will be transferred to the legal reserve. This deduction ceases to be

compulsory when the legal reserve amounts to ten percent (10%) of the issued capital.

The general meeting of shareholders may decide, at the majority vote determined by the Law, that the excess be

distributed to the shareholders proportionally to the shares they hold, as dividends or be carried forward or transferred
to an extraordinary reserve.

Art. 17. Interim dividends. Notwithstanding the provisions of article 16 of the Articles and subject to the prior approval

or ratification by the general meeting of shareholders, the board of managers may decide to pay interim dividends before
the end of the current financial year, on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are available
for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of
the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward
losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or the Articles.

Art. 18. Winding-up - Liquidation. The general meeting of shareholders at the majority vote determined by the Law,

or the sole shareholder (as the case may be) may decide the dissolution and the liquidation of the Company as well as
the terms thereof.

The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general

meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) which will specify their powers and determine their
remuneration.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be allocated to the shareholder(s)

proportionally to the shares they hold.

146994

L

U X E M B O U R G

Art. 19. General provision. Reference is made to the provisions of the Law for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Subscription and payment

The one hundred and twenty five (125) shares have been subscribed by MELAMPYRE SA prenamed.
All the shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred Euros (EUR

12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitory disposition

The first financial year starts on the incorporation date of the Company and terminates on 31 December 2015.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one hundred two hundred euros (EUR
1,200.-).

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-

scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1) Have been appointed as managers for an undetermined period of time:
- Mr. Marc Ambroisien, Director, born in Thionville(France), on the 8 March 1962, professionally residing at L-2535

Luxembourg, 16 Boulevard Emmanuel Servais.

- Mrs. Elise Lethuillier, Vice-Director, born in Dreux (France), on the 17 November 1972, professionally residing at

L-2535 Luxembourg, 16 Boulevard Emmanuel Servais.

2) The Company shall have its registered office at 16, Boulevard Emmanuel Servais L-2535 Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing

party represented as stated hereabove, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version;
on request of the same party and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version
will prevail.

In faith of which we, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg, on the day named at the beginning

of this document.

The document having been read to the proxy-holder of the appearing party, known to the notary by name, first name,

civil status and residence, said person signed with us, the Notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille quatorze, le neuf septembre
Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU

MELAMPYRE SA, une Société Anonyme ayant son siège social à Luxembourg L-2535, 16 Boulevard Emmanuel Servais,

RCS Luxembourg B160196,

ici représentée par Laurence Diettert, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une

procuration donnée sous seing privé à Luxembourg en date du 05 septembre 2014.

La procuration signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera annexée

au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

La comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis du notaire instrumentaire qu'il dresse comme suit les statuts

(les «Statuts») d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare constituer comme associé ou avec toute personne ou
entité qui deviendrait associé de la société par la suite:

Art. 1 

er

 . Dénomination.  Il est constitué par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination

«TOOLE S.à r.l.» (la «Société»), régie par les présents Statuts et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur
et en particulier la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la «Loi»), et les lois du 18 septembre 1933 et 28
décembre 1992 sur les sociétés à responsabilité limitée.

Art. 2. Objet. L'objet de la Société est l’acquisition d'intérêts de propriété, au Grand-duché de Luxembourg ou à

l’étranger, dans toutes sociétés ou entreprises, sous quelque forme que ce soit ainsi que la gestion de ces intérêts de
propriété. La Société peut notamment acquérir par voie de souscription, achat ou échange ou par tout autre moyen
toutes valeurs, actions et titres/garanties de quelque nature que ce soit en ce compris les obligations, certificats, certificats
de dépôt et tous autres instruments et plus généralement tous titres/garanties, instruments financiers émis par une entité

146995

L

U X E M B O U R G

privée ou publique quelle qu'elle soit. La Société peut également participer dans la création, le développement et le
contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut également investir dans l’acquisition et la gestion d'un portefeuille de
brevets et autres droits de propriété intellectuelle.

La Société pourra coordonner les activités de toutes les entités au sein desquelles elle détient directement ou indi-

rectement des participations.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, par voie

de placement privé, à l’émission de créances et obligations et autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de créances
négociables. La Société peut prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations
à ses filiales, sociétés affiliées et sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société. Elle peut également
consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de
ses filiales, sociétés affiliées ou sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société peut en outre gager, hypothéquer, céder ou de tout autre manière grever tout ou partie de ses actifs. La

Société peut en général employer toutes techniques et utiliser tous instruments en relation avec ses investissements en
vue de leur gestion optimale, incluant les techniques et instruments en vue de protéger la société contre les risques de
crédit, de fluctuation des devises et des taux d'intérêts et autres risques.

La Société peut exercer toutes activités commerciales, financières ou industrielles et effectuer toutes transactions dans

le domaine immobilier ou relatives à des biens immobiliers.

La Société peut exercer toutes activités commerciales, financières ou industrielles qui peuvent être ou qui sont con-

formes aux paragraphes mentionnés ci-dessus dans cet Article 2.

Art. 3. Siège social. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu de la commune de Luxembourg par décision du conseil de gérance.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger par décision de l’assemblée

générale extraordinaire des associés prise dans les conditions requises par les Statuts.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou des succursales (permanents ou non) au Luxembourg et à l’étranger.
Au cas où le conseil de gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou

social de nature à compromettre l’activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège
avec l’étranger, se sont produits ou sont imminents, elle pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger
jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la
nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Pareille mesure
temporaire sera prise et portée à la connaissance des tiers par le conseil de gérance de la Société.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Art. 5. Capital. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENT euros (EUR 12.500,-), représenté par CENT

VINGT CINQ (125) parts sociales d'une valeur nominale de CENT (EUR 100,-) chacune.

Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des associés adoptée

dans les conditions requises pour la modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales. Chaque part sociale confère un droit de vote identique et chaque associé dispose de droits de

vote proportionnels à sa participation au capital social.

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée sans l’agrément donné par

les associés représentant au moins les trois quarts du capital social réunis en assemblée générale.

Pour le surplus, les dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales s'appli-

queront.

Les parts sont indivisibles à l’égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle.
La Société pourra procéder au rachat de ses propres parts sociales.
Un tel rachat ne pourra être décidé que par une résolution unanime de l’assemblée générale extraordinaire des associés

représentant la totalité du capital souscrit de la Société.

Art. 7. Gérance. La société sera gérée par au moins un gérant. Dans le cas où plus d'un gérant serait nommé, les gérants

formeront un conseil de gérance.

Les gérants peuvent ne pas être associés.
Les gérants sont désignés par décision de l’assemblée générale des associés délibérant à la majorité simple des voix,

ou le cas échéant, par décision de l’associé unique qui détermine l’étendue de leurs pouvoirs, leur rémunération et la
durée de leur mandat. L'assemblée générale des associés ou le cas échéant, l’associé unique, pourra à tout moment, et
ad nutum révoquer et remplacer tout gérant.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés ou le cas échéant à l’associé unique,

par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du conseil de gérance.

146996

L

U X E M B O U R G

Art. 8. Représentation. Dans le cas d'un gérant unique, la seule signature de ce gérant liera la Société. Dans le cas de

pluralité de gérants, la Société sera engagée par la signature conjointe de deux gérants pour tout engagement supérieur
à 10.000,- EUR (dix mille euros). Un gérant pourra déléguer ou subdéléguer sa signature à un autre gérant. Chaque
délégation devra faire l’objet d’une notification expresse de la part du gérant mandant au gérant mandataire. Cette noti-
fication pourra être adressée par courrier, courrier électronique ou télécopie.

Le conseil de gérance peut ponctuellement subdéléguer ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs

agents ad hoc, lequel peut ne pas être associé(s) ou gérant(s) de la Société.

Le conseil de gérance détermine les responsabilités et la rémunération (s'il y a lieu) de ce(s) agent(s), la durée de son/

leurs mandat(s) ainsi que toutes autres conditions de son/leurs mandat(s).

Art. 9. Procédure. En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance choisit parmi ses membres un président. Il peut

également choisir un secrétaire, lequel n'est pas nécessairement gérant, qui est responsable de la rédaction du procès-
verbal de réunion du conseil de gérance ou pour d'autres fins telles que spécifiées par le conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunit sur convocation de l’un d'entre eux.
Une convocation à une réunion du conseil de gérance devra être adressée à chacun des gérants avant la date fixée

pour cette réunion, sauf urgence, dont la nature devra alors figurer dans le procès-verbal de réunion.

Toute convocation devra spécifier l’heure, le lieu et l’ordre du jour de la réunion.
Convocation peut être adressée à chaque gérant oralement, par écrit, télécopie ou tout autre moyen électronique de

communication approprié.

Il peut être renoncé à la convocation par consentement écrit, par télécopie ou tout autre moyen électronique de

communication approprié de chaque gérant.

La réunion est valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou dûment représentés.
Le conseil de gérance ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.
Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant pour le

représenter. Un gérant peut représenter plus d'un gérant.

Tout gérant peut assister à une réunion du conseil de gérance par téléphone, vidéoconférence, ou tout autre moyen

de télécommunication approprié permettant à toutes les personnes participant à la réunion de s'entendre en même temps.
Une telle participation à une réunion est réputée équivalente à une participation en personne à une réunion des gérants.

Sauf dispositions contraires des Statuts, les décisions du conseil de gérance sont adoptées par majorité simple des

gérants, présents ou représentés.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produit effet au même titre qu'une décision

prise à une réunion du conseil de gérance.

Dans ce cas, les résolutions ou décisions sont expressément prises, soit formulées par écrit par voie circulaire, par

courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de télécommunication
approprié.

Une résolution écrite peut être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même

contenu.

Les délibérations du conseil de gérance sont transcrites par un procès-verbal, qui est signé par le président.

Art. 10. Responsabilité des gérants. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle

quant aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire de la Société, il n'est responsable
que de l’exécution de son mandat.

Art. 11. Assemblées générales des associés. Les assemblées générales des associés sont convoquées par le conseil de

gérance ou, à défaut, par des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

Une convocation écrite à une assemblée générale indiquant l’ordre du jour est faite conformément à la Loi et est

adressée à chaque associé par voie postale et/ou par voie électronique. Toutes les convocations doivent spécifier la date
et le lieu de l’assemblée.

Si tous les associés sont présents ou représentés à l’assemblée générale et indiquent avoir été dûment informés de

l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut se faire représenter à toute assemblée générale en désignant par écrit un tiers qui peut ne pas être

associé.

Les résolutions ne sont valablement adoptées en assemblées générales que pour autant qu'elles soient prises par des

associés représentant plus de la moitié du capital social.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des Statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des

associés représentant au moins trois quarts du capital social.

Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la Loi.
En conséquence, l’associé unique prend toutes les décisions excédant les pouvoirs du conseil de gérance.

146997

L

U X E M B O U R G

Art. 12. Assemblée générale annuelle. Une assemblée générale des associés se réunira annuellement pour l’approbation

des comptes annuels, au plus tard dans les six mois de la clôture de l’exercice social, au siège de la Société ou en tout
autre lieu à spécifier dans la convocation de cette assemblée.

Art. 13. Exercice social. L'exercice social commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 14. Comptes annuels. A la clôture de chaque exercice social, le conseil de gérance établira les comptes annuels

qui contiendront l’inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes actives et passives.

Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire, du bilan et du compte de profits

et pertes.

Art. 15. Surveillance de la société. Si le nombre des associés excède vingt-cinq, la surveillance de la société sera confiée

à un ou plusieurs commissaire(s), qui peut ne pas être associé.

Chaque commissaire sera nommé pour une période expirant à la date de l’assemblée générale des associés suivant sa

nomination.

A l’expiration de cette période, le(s) commissaire(s) pourra/pourront être renouvelé(s) dans ses/leurs fonction(s) par

une nouvelle décision de l’assemblée générale des associés.

Lorsque les seuils fixés par l’article 35 de la loi de 19 Décembre 2002 sur le registre de commerce et des sociétés,

ainsi que la comptabilité et les comptes annuels, telle que modifiée, seront atteints, la Société confiera le contrôle de ses
comptes à un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises désigné(s) par résolution de l’assemblée générale des associés ou le
cas échéant par l’associé unique, parmi les membres de l’Institut des réviseurs d'entreprises.

Nonobstant les seuils ci-dessus mentionnés, à tout moment, un ou plusieurs réviseurs peuvent être nommés par

résolution de l’assemblée générale des associés ou le cas échéant de l’associé unique, qui décide des termes et conditions
de son/leurs mandat(s).

Art. 16. Répartition des bénéfices. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais,

charges, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint dix pour cent (10%) du capital

social.

L'assemblée générale des associés peut décider, à la majorité des voix telle que définie par la Loi, de distribuer au titre

de dividendes le solde du bénéfice net entre les associés proportionnellement à leurs parts sociales, ou de l’affecter au
compte report à nouveau ou à un compte de réserve spéciale.

Art. 17. Dividende intérimaire. Nonobstant les dispositions de l’article seize des Statuts, et sous réserve d'une appro-

bation préalable ou ratification de l’assemblée générale des associés, le conseil de gérance peut décider de payer des
acomptes sur dividendes en cours d'exercice social sur base d'un état comptable duquel il devra ressortir que des fonds
suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant
des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice social, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables
mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.

Art. 18. Dissolution - Liquidation. L'assemblée générale des associés, statuant à la majorité des voix telle que fixée par

la Loi, ou le cas échéant l’associé unique peut décider la dissolution ou la liquidation de la Société ainsi que les termes et
conditions de celle-ci.

La liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés

par l’assemblée générale des associés ou l’associé unique, le cas échéant, qui détermine leurs pouvoirs et rémunérations.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés proportionnellement à leur participation.

Art. 19. Disposition générale. Il est renvoyé aux dispositions de la Loi pour l’ensemble des points au regard desquels

les présents statuts ne contiennent aucune disposition spécifique.

<i>Souscription et libération

«MELAMPYRE SA», prénommée, a souscrit CENT VINGT CINQ (125) parts sociales.
Toutes les parts souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de DOUZE MILLE CINQ

CENT euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2015.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ mille deux cents euros (EUR 1.200,-).

146998

L

U X E M B O U R G

<i>Résolutions de l’associé unique

Immédiatement après la constitution de la Société, la comparante précitée, représentant la totalité du capital social,

exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:

Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
- Monsieur Marc Ambroisien, Directeur, né à Thionville, le 08 mars 1962, demeurant professionnellement à L-2535

Luxembourg, 16 Boulevard Emmanuel Servais.

- Madame Elise Lethuillier, Directeur adjoint, née à Dreux (France) le 17 novembre 1972, demeurant professionnel-

lement à L-2535 Luxembourg, 16 Boulevard Emmanuel Servais.

2) Le siège social de la Société est établi au 16 Boulevard Emmanuel Servais L-2535 Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par les présentes qu'à la requête de la partie comparante,

représentée comme dit ci-avant, les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française, à la requête
de la même partie et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, es qualités qu'il agit, connu du

notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec nous notaire le présent acte.

Signé: L.DIETTERT, J.ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils le 10 septembre 2014. Relation: LAC/2014/42004. Reçu soixante-quinze euros

(EUR 75,-).

<i>Le Receveur (signé): C. FRISING.

Référence de publication: 2014143124/417.
(140162137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2014.

Gsmp VI Offshore International Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 190.076.

STATUTES

In the year two thousand fourteen, on the twenty-eighth day of August;
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg);

THERE APPEARED:

“GS Mezzanine Partners VI Offshore, L.P.”, an exempted limited partnership formed under the laws of The Cayman

Islands, having its registered office at c/o M&amp;C Corporate Services Limited, P.O. Box 309GT, George Town, Grand
Cayman, Cayman Islands, British West Indies, registered with the Registrar of Limited Partnership of The Cayman Islands
under registration number MC-75113, acting through its general partner GS Mezzanine Partners VI Sponsor, L.L.C.,

here represented by Mrs. Christèle PIERRE-ALEXANDRE, lawyer, with professional address at 2, rue Peternelchen,

in L-2370 Howald (Grand Duchy of Luxembourg), by virtue of a proxy given under private seal, such proxy, after having
been signed "ne varietur" by the proxy-holder and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order
to be recorded with it.

Such appearing party, represented as stated above, has requested the notary to draw up the following articles of

incorporation of a société à responsabilité limitée, which it declares to form:

Title I. - Object - Denomination - Registered office - Duration

Art. 1. There is hereby formed a société à responsabilité limitée governed by actual laws, in particular the law of August

10 

th

 , 1915 on commercial companies, as amended from time to time, the law of September 18 

th

 , 1933 on limited

liability companies, as amended, as well as the present articles of incorporation.

Art. 2. The denomination of the company is “GSMP VI Offshore International Holdings S.à r.l.”.

Art. 3. The registered office of the company is established in Luxembourg.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at

the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared
to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the

registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the company, which is best
situated for this purpose under such circumstances.

146999

L

U X E M B O U R G

Art. 4. The objects of the Company are:
- to act as an investment holding company and to co-ordinate the business of any corporate bodies in which the

Company is for the time being directly or indirectly interested, and to acquire (whether by original subscription, tender,
purchase, exchange or otherwise) the whole of or any part of the stock, shares, debentures, debenture stocks, bonds
and other securities issued or guaranteed by any person and any other asset of any kind and to hold the same as invest-
ments, and to sell, exchange and dispose of the same;

- to hold any shares, debentures and other securities so acquired; to improve, manage, develop, sell, exchange, lease,

mortgage, dispose of, grant options over, turn to account and otherwise deal with all or any part of the property and
rights of the Company;

- to carry on any trade or business whatsoever and to acquire, undertake and carry on the whole or any part of the

business, property and/or liabilities of any person carrying on any business;

- to invest and deal with the Company's money and funds in any way the board of managers think fit and to lend money

and give credit in each case to any person with or without security;

- to borrow, raise and secure the payment of money in any way the board of managers think fit, including by the issue

(to the extent permitted by Luxembourg law) of debentures and other securities or instruments, perpetual or otherwise,
convertible or not, whether or not charged on all or any of the Company's property (present and future) or its uncalled
capital, and to purchase, redeem, convert and pay off those securities;

- to acquire an interest in, amalgamate, merge, consolidate with and enter into partnership or any arrangement for

the sharing of profits, union of interests, co-operation, joint venture, reciprocal concession or otherwise with any person,
including any employees of the Company;

- to enter into any guarantee or contract of indemnity or surety-ship, and to provide security, including the guarantee

and provision of security for the performance of the obligations of and the payment of any money (including capital,
principal, premiums, dividends, interest, commissions, charges, discount and any related costs or expenses whether on
shares or other securities) by any person including any body corporate in which the Company has a direct or indirect
interest or any person which is for the time being a member or otherwise has a direct or indirect interest in the Company
or is associated with the Company in any business or venture, with or without the Company receiving any consideration
or advantage (whether direct or indirect), and whether by personal covenant or mortgage, charge or lien over all or part
of  the  Company's  undertaking,  property,  assets  or  uncalled  capital  (present  and  future)  or  by  other  means;  for  the
purposes of this Article 4 "guarantee" includes any obligation, however described, to pay, satisfy, provide funds for the
payment or satisfaction of (including by advance of money, purchase of or subscription for shares or other securities and
purchase of assets or services), indemnify and keep indemnified against the consequences of default in the payment of,
or otherwise be responsible for, any indebtedness of any other person;

- to do all or any of the things provided in any paragraph of this Article 4 (a) in any part of the world; (b) as principal,

agent, contractor, trustee or otherwise; (c) by or through trustees, agents, sub-contractors or otherwise; and (d) alone
or with another person or persons;

- to do all things (including entering into, performing and delivering contracts, deeds, agreements and arrangements

with or in favor of any person) that are in the opinion of the board of managers incidental or conducive to the attainment
of all or any of the Company's objects, or the exercise of all or any of its powers;

PROVIDED ALWAYS that the Company will not enter into any transaction which would constitute a regulated activity

of the financial sector or require a business license under Luxembourg law without due authorisation under Luxembourg
law.

Art. 5. The company is formed for an unlimited period of time.

Title II. - Capital - Parts

Art. 6. The capital is fixed at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) represented by one million two

hundred and fifty thousand (1,250,000) shares with a nominal value of one cent Euro (EUR 0.01) each.

The company shall have an authorized capital of one hundred million Euros (EUR 100,000,000.-) represented by ten

billion (10,000,000,000) shares having a par value of one cent Euro (EUR 0.01) each.

The board of managers is authorised and appointed:
- to increase from time to time the subscribed capital of the company within the limits of the authorised capital, at

once or by successive portions, by issuance of new shares with or without share premium, to be paid up in cash, by
contribution in kind, by conversion of shareholders' claims, by conversion of convertible preferred equity certificates or
other  convertible  notes  or  similar  instruments  or,  upon  approval  of  the  annual  general  meeting  of  shareholders,  by
incorporation of profits or reserves into capital;

- to determine the place and the date of the issuance or of the successive issuances, the terms and conditions of

subscription and payment of the additional shares.

Such authorisation is valid for a period of five years starting from the date of publication of the present deed.
The period of this authority may be extended by resolution of the sole shareholder or, as the case may be, of the

general meeting of shareholders, from time to time, in the manner required for amendment of these articles of association.

147000

L

U X E M B O U R G

The board of managers is authorised to determine the conditions attached to any subscription for shares. In case of

issuance of shares, the board of managers of the Company may, in its sole discretion, decide the amounts to be issued.

When the board of managers effects a whole or partial increase in capital pursuant to the provisions referred to above,

it shall be obliged to take steps to amend this article in order to record the change and the Company’s management is
authorised to take or authorise the steps required for the execution and publication of such amendment in accordance
with the law.

Art. 7. Every share entitles its owner to one vote.
Shares are freely transferable among shareholders. Transfer of shares inter vivos to non-shareholders may only be

made with the prior approval of shareholders representing three quarters of the corporate capital.

Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the law of August 10 

th

 , 1915 on commercial

companies.

The shares are indivisible with regard to the company, which admits only one owner for each of them.
Shares in the company shall not be redeemable at the request of a shareholder.
The company, however, may redeem its shares whenever the board of managers considers this to be in the best

interest of the company, subject to the terms and conditions it shall determine and within the limitations set forth by
these articles and by law.

Unless the share redemption is immediately followed by a share capital reduction, any such redemption shall only be

made out of the company’s retained profits and non-compulsory reserves, including any paid-in surplus but excluding any
reserve required by Luxembourg law. The redemption price shall be determined by the board of managers.

Art. 8. The life of the company does not terminate by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of any

shareholder.

Art. 9. A shareholder as well as the heirs and representatives or entitled persons and creditors of a shareholder cannot,

under any circumstances, request the affixing of seals on the assets and documents of the company, nor become involved
in any way in its administration.

In order to exercise their rights they have to refer to financial statements and to the decisions of the general meetings.

Title III. - Management

Art. 10. The company is managed by one or several managers, who need not be shareholders.
In case of plurality of managers, the managers shall form a board of managers being the corporate body in charge of

the Company’s management and representation. To the extend applicable and where the term “sole manager” is not
expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of
association shall be read as a reference to the “sole manager”.

The managers will be appointed by the general meeting of shareholders with or without limitation of their period of

office. The general meeting of shareholders has the power to remove managers at any time without giving reasons.

The board of managers elects among its members a chairman; in the absence of the chairman, another manager may

preside over the meeting.

A manager unable to take part in a meeting may delegate by letter, telex, telefax or telegram another member of the

board to represent him at the meeting and to vote in his name.

Any member of the board of managers who participates in the proceedings of a meeting of the board of managers by

means of a communications device (including a telephone or a video conference) which allows all the other members of
the board of managers present at such meeting (whether in person, or by proxy, or by means of such communications
device) to hear and to be heard by the other members at any time shall be deemed to be present in person at such
meeting, and shall be counted when reckoning a quorum and shall be entitled to vote on matters considered at such
meeting. Members of the board of managers who participate in the proceedings of a meeting of the board of managers
by means of such a communications device shall ratify their votes so cast by signing one copy of the minutes of the meeting.

The board of managers convenes upon call by the chairman, or any third party delegated by him or by any manager,

as often as the interest of the company so requires.

The board of managers can validly deliberate and act only if the majority of managers is present or represented.
Resolutions shall be passed with the favourable vote of the majority of managers present or represented.
Circular resolutions signed by all members of the board of managers will be as valid and effective as if passed at a

meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical
resolution.

The resolutions of the board of managers will be recorded in minutes signed by all of the members who took part at

the deliberation.

Copies or extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or elsewhere will be validly signed by the

chairman of the meeting or any two managers.

147001

L

U X E M B O U R G

Art. 11. The board of managers is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in compliance with the corporate object.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-

holders fall within the competence of the board of managers.

The board of managers may pay interim dividends, provided that prior to such authorisation, the board of managers

shall be in possession of interim accounts of the company, which provide evidence that sufficient funds are available to
pay such interim dividend.

In the event of a vacancy on the board of managers, the remaining managers have the right to provisionally fill the

vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.

The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of the

first managers will be determined in the act of nomination.

Art. 12. The board of managers may delegate its powers to conduct the daily management of the company to one or

more managers, who will be called managing director(s).

The board of managers may also delegate the power of company’s representation to one or several managers or to

any other person, shareholder or not, who will represent individually or jointly the company for specific transactions as
determined by the board of managers.

Any manager, appointed as described in the previous paragraph, may issue a power of attorney, by his or her sole

signature, as required, in order to give a special power to an attorney (ad hoc agent) to represent individually the company
for specific purposes as determined in the special power of attorney.

Art. 13. The company is bound by the sole signature of any one manager for decisions having a value of an amount of

up to ten thousand Euros (EUR 10,000.-). For decisions having a value of an amount over ten thousand Euros (EUR
10,000.-), the company is bound by the signature of its sole manager and in case of plurality of managers, by the joint
signature of at least two managers.

Art. 14. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly

taken by him in the name of the company; as a proxy holder he is only responsible for the execution of his mandate.

Title IV. - General meeting of the shareholders

Art. 15. The sole shareholder shall exercise all powers vested with the general meeting of shareholders under section

XII of the law of August 10 

th

 , 1915 on commercial companies as amended.

All decisions exceeding the powers of the board of managers shall be taken by the sole shareholder or, as the case

may be, by the general meeting of the shareholders. Any such decisions shall be in writing and shall be recorded on a
special register.

In case there is more than one but less than twenty-five shareholders, decisions of shareholders shall be taken in a

general meeting or by written consultation at the initiative of the board of managers. No decision is deemed validly taken
until it has been adopted by the shareholders representing more than fifty per cent (50%) of the capital.

General meetings of shareholders shall be held in Luxembourg. Attendance by virtue of proxy is possible.

Title V. - Financial year - Profits - Reserves

Art. 16. The company's financial year runs from the first of January to the thirty-first of December of each year.

Exceptionally the first financial year shall begin on the day of incorporation and close on December 31 

st

 , 2015.

Art. 17. Each year, as of December 31 

st

 , the board of managers will draw up the balance sheet, which will contain a

record of the property of the company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing
a summary of all the commitments and debts of the Managers to the company.

At the same time the board of managers will prepare a profit and loss account, which will be submitted to the general

meeting of shareholders together with the balance sheet.

Art. 18. Each shareholder may inspect at the registered office the inventory, the balance sheet and the profit and loss

account during the fortnight preceding the annual general meeting.

Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges

and provisions represents the net profit of the company.

Each year, five percent (5%) of the net profit will be transferred to the statutory reserve. This deduction ceases to be

compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the capital but must be resumed until the reserve fund
is entirely reconstituted if, any time and for any reason whatever, it has been touched. The balance is at the disposal of
the general meeting of shareholders.

Art. 20. In the event of a dissolution of the company, the liquidation will be carried out by one or more liquidators

who need not to be shareholders, designated by the meeting of shareholders at the majority defined by article 142 of the
law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended.

147002

L

U X E M B O U R G

The liquidator(s) shall be invested with the broadest powers for the realization of the assets and payment of the debts.

Art. 21. For all matters not provided for in the present articles of incorporation, the parties refer to the existing laws.

<i>Subscription - Payment

The articles of incorporation having thus been established, the appearing party declares to subscribe the capital as

follows:

GS Mezzanine Partners VI Offshore, L.P., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,250,000 shares
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,250,000 shares

The shares have been fully paid up by payment in cash, so that the amount twelve thousand five hundred Euros (EUR

12,500.-) is now available to the company, evidence thereof having been given to the notary.

<i>Declaration

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 183

of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, and expressly states that they have been fulfilled.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

company incurs or for which it is liable by reason of its organisation, is approximately one thousand Euros (EUR 1,000.-).

<i>Resolutions taken by the sole shareholder

The aforementioned appearing party, representing the whole of the subscribed share capital, has adopted the following

resolutions as sole shareholder:

1) The number of managers is fixed at five (5).
2) Are appointed as managers for an unlimited period:
- Marielle STIJGER, Director, born in Capelle aan den IJssel, The Netherlands, on 10 December 1969, professionally

residing at 2 rue du Fossé, L-1536 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

- Dominique LE GAL, Director, born in Savigny-Sur-Orge, France, on 9 December 1971, professionally residing at 2,

rue du Fossé, L-1536 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

- Michael FURTH, Director, born in Geneva, Switzerland on 29 April 1968, professionally residing at Peterborough

Court, 133 Fleet Street, London EC4A 2BB, United Kingdom; and

- Sam AGNEW, Director, born in London, England on 23 May 1974, professionally residing at Peterborough Court,

133 Fleet Street, London EC4A 2BB, United Kingdom

- GS Lux Management Services S.à r.l., a société à responsabilité limitée existing under the laws of the Grand Duchy

of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 88.045.

3) The company shall have its registered office at 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above

appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
party, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the proxy-holder of the appearing party, acting as said before, known to the notary

by name, first name, civil status and residence, the said proxy-holder has signed with Us, the notary, the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le vingt-huitième jour d'août;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg);

A COMPARU:

«GS Mezzanine Partners VI Offshore, L.P.», un exempted limited partnership constitué et opérant sous le droit des

Iles Caymans, immatriculée auprès du Registrar of Limited Partnership of The Cayman Islands sous le numéro MC-75113,
ayant son siège social à C/O M&amp;C Corporate Services Limited, P.O. Box 309GT, George Town, Grand Cayman, Cayman
Islands, British West Indies, agissant par l’intermédiaire de son «general partner» GS Mezzanine Partners VI Sponsor,
L.L.C.,

ici représentée par Madame Christèle PIERRE-ALEXANDRE, avocat, demeurant professionnellement à L-2165 Lu-

xembourg, 2, rue Peternelchen, L-2370 Howald (Grand-Duché de Luxembourg), en vertu d'une procuration sous seing
privé lui délivrée, laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par la mandataire et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.

147003

L

U X E M B O U R G

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a déclaré vouloir constituer par le présent acte une

société à responsabilité limitée et a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts:

Titre 1 

er

 . - Objet - Dénomination - Siège social - Durée

Art. 1 

er

 .  Il est formé par le présent acte une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois actuellement

en vigueur, notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, par celle du 18
septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La dénomination de la société est «GSMP VI Offshore International Holdings S.à r.l.».

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se sont produits ou sont
imminents, le siège social peut être transféré provisoirement à l’étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n'aura cependant aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du siège

sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui est le mieux placé pour le faire dans ces
circonstances.

Art. 4. L'objet de la Société est:
- d'agir en tant que société holding d'investissement et de coordonner l’activité de toutes entités dans lesquelles la

Société a un intérêt direct ou indirect, et d'acquérir (soit par souscription originale, offre publique, achat, échange ou
autre) la totalité ou une partie du capital, des actions, des obligations, des bons ou autres titres émis ou garantis par toute
personne et tout autre actif et de les détenir en tant qu'investissements, de les vendre, de les échanger et d'en disposer;

- de détenir toutes actions, obligations et autres titres ainsi acquis; d'améliorer, gérer, développer, vendre, échanger,

louer, hypothéquer, disposer de, octroyer des options sur, ou négocier la totalité ou une partie des biens et droits de la
Société;

- de réaliser tout commerce ou affaires de toutes sortes et d'acquérir, entreprendre ou poursuivre tout ou une partie

des affaires, des biens et/ou passifs de toute personne réalisant des affaires;

- d'investir et de négocier de l’argent et les fonds de la Société de quelque manière que le conseil de gérance estime

adéquate et de prêter de l’argent et d'octroyer crédit à toute personne avec ou sans garantie;

- d'emprunter, lever ou garantir le paiement de sommes d'argent de quelque manière que le conseil de gérance estime

adéquate, incluant l’émission (dans le cadre permis par la Loi Luxembourgeoise) d'obligations et autres titres ou instru-
ments financiers, perpétuels ou autre, convertibles ou non, à payer ou non sur la totalité ou une partie des biens de la
Société (présents et futurs) ou sur son capital non encore libéré, et d'acheter, racheter, convertir et rembourser ces
titres;

- d'acquérir tout intérêt dans, fusionner avec, ou entrer dans tout partenariat ou accord relatif au partage de profits,

l’union d'intérêts, la coopération, la participation en société, la concession mutuelle ou autre, avec toute personne, incluant
tout employé de la Société;

- de conclure toute garantie ou tout engagement d'indemniser, et de fournir toute sûreté incluant les garanties et

octroi de sûretés pour la réalisation d'obligations et le paiement de toute somme d'argent (incluant le capital, le principal,
les primes, dividendes, intérêts, commissions, charges, escomptes ou tous coûts relatifs ou dépenses sur actions ou autre
titres) par toute personne incluant toute entité sociale dans laquelle la Société a un intérêt direct ou indirect ou toute
personne étant membre ou ayant un intérêt direct ou indirect dans la Société ou étant associée avec la Société dans toute
activité ou entreprise, que la Société en reçoive ou non une contrepartie ou un avantage (direct ou indirect), soit par
engagement personnel ou hypothèque, sûreté ou privilège sur tout ou une partie du fonds de commerce, des biens, des
actifs ou du capital non encore libéré de la Société (présent et futur) ou par tout autre moyen; pour les besoins du présent
Article 4 «garantie» inclut toute obligation, quel qu'en soit le libellé, de payer, satisfaire, fournir des fonds pour le paiement
ou la satisfaction de (incluant l’avance d'argent, l’achat ou la souscription d'actions ou autres titres et l’achat d'actifs ou
de services), d'indemniser et maintenir indemnisé contre les conséquences d'un défaut de payement, ou d'être respon-
sable, de toute autre manière, des dettes de toute autre personne;

- de faire toute chose prévue aux paragraphes du présent Article 4 (a) dans toute partie du monde; (b) en tant que

commettant, agent, le contractant, fiduciaire ou autre; (c) par l’intermédiaire de fiduciaires, agents, sous-contractants ou
autres; (d) seul ou avec d'autre(s) personne(s);

- de faire toutes choses (incluant conclure, réaliser ou délivrer des contrats, actes, accords et arrangements avec ou

en faveur de toute personne) que le conseil de gérance considère comme incitant ou propice à l’accomplissement de tout
ou partie de l’objet social de la Société, ou l’exercice de tout ou partie des pouvoirs de celle-ci;

SOUS RESERVE que la Société n’entrera jamais dans aucune opération qui constituerait une activité réglementée du

secteur financier ou qui exigerait une licence professionnelle conformément à la Loi Luxembourgeoise, sans l’autorisation
requise par celle-ci.

147004

L

U X E M B O U R G

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Titre Il. - Capital - Parts

Art. 6. Le capital social de la société est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500.-) divisé en un million deux

cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales ayant une valeur nominale d’un centime d’Euro (EUR 0,01) chacune, en-
tièrement souscrites et libérées.

La Société aura un capital social autorisé de cent millions d’Euros (EUR 100.000.000.-) représenté par dix milliards

(10.000.000.000) de parts sociales ayant une valeur nominale d’un centime d’Euro (EUR 0,01) chacune.

Le conseil de gérance est autorisé à, et mandaté pour:
- augmenter le capital social de la société dans les limites du capital autorisé, en une seule fois ou par tranches suc-

cessives, par émission de parts sociales nouvelles avec ou sans prime d’émission, à libérer par voie de versements en
espèces, d'apports en nature, par conversion de créances, par conversion de titres préférentiels convertibles ou d’autres
titres convertibles ou instruments similaires ou, sur approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d'incorporation
de bénéfices ou réserves au capital;

- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération de parts sociales nouvelles;

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte.
La durée de cette autorisation peut être étendue par décision de l’associé unique ou, selon le cas, par l’assemblée

générale des associés, statuant comme en matière de modification des présents statuts.

Le conseil de gérance est autorisé à déterminer les conditions de souscription des parts sociales. En cas d’émission de

parts sociales, le conseil de gérance de la Société peut décider, à sa seule discrétion, du total des émissions.

Lorsque le conseil de gérance effectue une augmentation partielle ou totale de capital conformément aux dispositions

mentionnées ci-dessus, il sera obligé de prendre les mesures nécessaires pour modifier cet article afin de constater cette
modification et la gérance de la Société est autorisée à prendre ou à autoriser toutes les mesures requises pour l’exécution
et la publication de telle modification conformément à la loi.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une voix.
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les cessions de parts sociales entre vifs à des tiers non

associés ne peuvent être effectuées que moyennant l’agrément préalable des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social.

Pour le reste, il est fait renvoi aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales telle que modifiée.

Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société qui n’admet qu'un seul titulaire à son égard pour chaque part.
Les parts sociales ne sont pas remboursables à la demande des associés.
La société peut, toutefois, lorsque le conseil de gérance considère que cela est dans l’intérêt de la société, aux con-

ditions et aux termes prévus par la loi et les statuts, racheter ses propres parts.

À moins que le rachat des parts soit immédiatement suivi par une réduction de capital, tout remboursement ne pourra

être effectué qu'au moyen des bénéfices non distribués de la société et des réserves disponibles, en ce compris les réserves
excédentaires, mais excluant les réserves légales prévues par la loi luxembourgeoise. Le prix de rachat sera déterminé
par le conseil de gérance.

Art. 8. La faillite, l’insolvabilité, le décès ou l’incapacité d’un associé ne mettent pas fin à la société.

Art. 9. Un associé ainsi que les héritiers et représentants ou ayants droit et créanciers d'un associé ne peuvent, sous

aucun prétexte, requérir l’apposition de scellés sur les biens et papiers de la société, ni s'immiscer en aucune manière
dans les actes de son administration.

Ils doivent pour l’exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées

générales.

Titre III. - Administration

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.
En cas de pluralité de gérants, les gérants constituent un conseil de gérance, étant l’organe chargé de la gérance et de

la représentation de la société. Dans la mesure où le terme «gérant unique» n’est pas expressément mentionné dans les
présents statuts, une référence au «conseil de gérance» utilisée dans les présents statuts doit être lue comme une réfé-
rence au «gérant unique».

Les gérants sont nommés par l’assemblée générale des associés, pour une durée limitée ou sans limitation de durée.

L’assemblée générale des associés peut révoquer les gérants à tout moment, avec ou sans motif.

Le conseil de gérance désigne parmi ses membres un président; en cas d'absence du président, la présidence de la

réunion peut être conférée à un autre gérant présent.

147005

L

U X E M B O U R G

Chaque gérant de la société empêché de participer à une réunion du conseil de gérance peut désigner par écrit,

télégramme, télex ou téléfax, un autre membre du conseil de gérance comme son mandataire, aux fins de le représenter
et de voter en son nom.

Tout membre du conseil de gérance qui participe à une réunion du conseil de gérance via un moyen de communication

(incluant le téléphone ou une vidéo conférence) qui permet aux autres membres du conseil de gérance présents à cette
réunion (soit en personne soit par mandataire ou au moyen de ce type de communication) d’entendre à tout moment
ce membre et permettant à ce membre d’entendre à tout moment les autres membres sera considéré comme étant
présent en personne à cette réunion et sera pris en compte pour le calcul du quorum et autorisé à voter sur les matières
traitées à cette réunion. Les membres du conseil de gérance qui participent à une réunion du conseil de gérance via un
tel moyen de communication ratifieront leurs votes exprimés de cette façon en signant une copie du procès-verbal de
cette réunion.

Le conseil de gérance se réunit sur la convocation du président, ou tout tiers délégué par lui ou par n’importe lequel

de ses gérants, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir que si une majorité de gérants sont présents ou représentés.
Les résolutions seront adoptées si elles ont été prises à la majorité des votes des membres présents soit en personne

soit par mandataire à telle réunion.

Les  résolutions  circulaires  signées  par  tous  les  membres  du  conseil  de  gérance  seront  considérées  comme  étant

valablement adoptées comme si une réunion valablement convoquée avait été tenue. Ces signatures pourront être ap-
posées sur un document unique ou sur des copies multiples d’une résolution identique.

Les résolutions du conseil de gérance seront enregistrées sur un procès-verbal signé par tous les membres qui ont

participé à la réunion.

Des copies ou extraits de ce procès-verbal à produire lors d’une procédure judiciaire ou ailleurs seront valablement

signés par le président de la réunion ou par deux gérants.

Art. 11. Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration et de

disposition qui rentrent dans l’objet social.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée

générale.

Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes à condition qu'avant toute distribution, le conseil de gérance soit

en possession de comptes intermédiaires de la société fournissant la preuve de l’existence de fonds suffisants à la distri-
bution de ces acomptes sur dividendes.

En cas de vacance d'une place au conseil de gérance, les gérants restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement des

premiers gérants seront déterminés dans l’acte de nomination.

Art. 12. Le conseil de gérance peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs gérants qui prendront

la dénomination de gérants délégués.

Le conseil de gérance peut également déléguer le pouvoir de représentation de la société à un ou plusieurs gérants

ou à toute autre personne, associé ou non, qui représentera la société individuellement ou conjointement pour des
transactions spécifiques tel que déterminé par le conseil de gérance.

Tout gérant, tel que désigné comme décrit dans le paragraphe précédent, peut donner pouvoir spécial, par sa seule

signature, à toute autre personne susceptible d’agir seule comme mandataire ad hoc de la société pour certaines tâches
telles que définies dans le pouvoir spécial.

Art. 13. La société est engagée par la seule signature d’un gérant pour toute décision ayant une valeur jusqu'à un

montant de dix mille Euros (EUR 10.000.-). Concernant les décisions ayant une valeur supérieure à dix mille Euros (EUR
10.000.-), la société est engagée par la signature de son gérant unique ou par les signatures conjointes d’au moins deux
gérants en cas de pluralité de gérants.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

Titre IV. - Assemblée générale des associés

Art. 15. L’associé unique exercera tous les droits incombant à l’assemblée générale des associés en vertu de la section

XII de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Toutes les décisions excédant le pouvoir du conseil de gérance seront prises par l’associé unique ou, selon les cas, par

l’assemblée générale des associés. Les décisions de l’associé unique seront écrites et doivent être consignées sur un
registre spécial.

147006

L

U X E M B O U R G

S’il y a plus d’un, mais moins de vingt-cinq associés, les décisions des associés seront prises par l’assemblée générale

ou par consultation écrite à l’initiative de la gérance. Aucune décision n’est valablement prise qu'autant qu'elle a été
adoptée par des associés représentant plus de la moitié (50%) du capital social.

Les assemblées générales des associés se tiendront au Luxembourg. La représentation au moyen de procuration est

admise.

Titre V. - Année comptable - Profits - Réserves

Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année, à l’exception du premier

exercice qui commence en date du jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2015.

Art. 17. Chaque année au 31 décembre, la gérance établit un état financier qui contiendra un inventaire de l’actif et du

passif de la société, ainsi qu'un compte de pertes et profits, accompagné d'une annexe contenant un résumé de tous les
engagements et dettes contractés par le conseil de gérance.

En même temps, le conseil de gérance dressera un compte de pertes et profits, qui sera soumis à l’assemblée générale

des associés en même temps que l’inventaire.

Art. 18. Chaque associé aura le droit de consulter l’inventaire au siège social, ainsi que le compte de pertes et profits,

pendant la quinzaine précédent l’assemblée générale annuelle.

Art. 19. Le solde positif du compte de pertes et profits, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements

et provisions, constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve; ce prélèvement cesse

d'être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital, mais devra toutefois être repris jusqu'à
entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.
L'excédent est à la libre disposition des associés.

Art. 20. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

à désigner par l’assemblée des associés à la majorité fixée par l’article 142 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les parties se rapportent aux dispositions légales

applicables.

<i>Souscription - Libération

Les statuts ayant été établis, le comparant déclare vouloir souscrire le total du capital de la manière suivante:

GS Mezzanine Partners VI Offshore, L.P., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.250.000 parts sociales
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.250.000 parts sociales

Les parts sociales ont été entièrement libérées à hauteur d'un montant de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-)

par un apport en numéraire de sorte que cette somme est à la disposition de la société à partir de ce moment tel qu'il a
été certifié au notaire instrumentaire.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, et en confirme expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élève approximativement à mille Euros (EUR 1.000,-).

<i>Résolutions prises par l’associée unique

La partie comparante pré-mentionnée, représentant l’intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions sui-

vantes en tant qu'associée unique:

1) Le nombre de gérants est fixé à cinq (5).
2) sont nommés gérants pour une période indéterminée:
- Marielle STIJGER, Director, née à Capelle aan den IJssel, Pays-Bas, le 10 décembre 1969, demeurant professionnel-

lement au 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

- Dominique LE GAL, Director, né à Savigny-Sur-Orge, France, le 9 décembre 1971, demeurant professionnellement

au 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

- Michael FURTH, Managing Director, né à Genève, Suisse, le 29 avril 1968, demeurant professionnellement à Peter-

borough Court, 133 Fleet Street, Londres EC4A 2BB, Royaume-Uni;

147007

L

U X E M B O U R G

- Sam AGNEW, Director, né à Londres, Royaume-Uni, le 23 mai 1974, demeurant professionnellement à Peterborough

Court, 133 Fleet Street, Londres EC4A 2BB, Royaume-Uni;

- GS Lux Management Services S.à r.l., une société à responsabilité limitée existant sous les lois du Grand-Duché de

Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 88.045.

3) Le siège social de la société est établi au 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais et le français, déclare par les présentes, qu'à la requête de la partie

comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même partie comparante,
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte à la mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire

par nom, prénom, état civil et domicile, ladite mandataire a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. PIERRE-ALEXANDRE, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 septembre 2014. LAC/2014/40808. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): Carole FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 10 septembre 2014.

Référence de publication: 2014142165/484.
(140161701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2014.

Bayerische Architektenversorgung &amp; Co. S.N.C., Société en nom collectif,

(anc. CCP III DK Germany S.à r.l.).

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 161.296.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-sixth of August,
Before Maître Martine SCHAEFFER, notary public residing at Luxembourg.

Was held

an extraordinary general meeting of the shareholders of "CCP III DK Germany S.à r.l", a société à responsabilité limitée

governed by the laws of Luxembourg, with registered office at L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur, having a share
capital of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) and registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register under number B 161.296 (the "Company").

The Company has been incorporated by Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, pursuant to a

deed dated 30 May 2011 and published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 1859
page 89215 dated 12 August 2011 (the "Articles"). The Articles have not yet been amended since the Company's incor-
poration.

The meeting is presided by Mrs Melissa KDYEM, lawyer.
The chairman appoints as secretary Mrs Franziska STAHLBERG, lawyer.
The meeting elects as scrutineer Mrs Judit STERN, lawyer.
The chairman requests the notary to act that:
I.- The shareholders represented (the "Shareholders") and the number of shares held by each of them are shown on

an attendance list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to
be registered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the twelve thousand find hundred (12,500) shares in registered form, repre-

senting the whole capital of the company, are duly represented so that the meeting is consequently regularly constituted
and can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders have been beforehand informed.

III.- The agenda of the meeting is the following:
1. Waiver of the convening notices;
2. Change of the legal form of the Company, in order to transform it into a general partnership (“société en nom

collectif” - S.N.C.);

3. As a consequence of the change of the legal form of the Company, change of the name of the Company into

“Bayerische Architektenversorgung &amp; Co. S.N.C.”;

4. Granting of discharge to the resigning managers of the Company;

147008

L

U X E M B O U R G

5. Appointment of the managing director of Bayerische Architektenversorgung &amp; Co. S.N.C.;
6. As a consequence of the above resolutions, full restatement of the articles of association of the Company without

change of its essential characteristics;

7. Miscellaneous.
These facts having been exposed and recognised as true by the meeting, the meeting unanimously decided on the

following:

<i>First resolution

The Shareholders note that they represent the entire capital of the Company, so that the meeting (the “Meeting”) can

validly decide on all the issues of the agenda, which are known to the Shareholders. The Shareholders resolve to waive
any applicable convening notices.

<i>Second resolution

The Meeting resolved to change the legal form of the Company in order to convert it from a private limited liability

company ("société à responsabilité limitée") into a general partnership ("société en nom collectif").

<i>Third resolution

As a consequence of the change of the legal form of the Company, the Meeting resolved to change the name of the

Company into "Bayerische Architektenversorgung &amp; Co. S.N.C.".

<i>Fourth resolution

The Meeting resolved to give full discharge to the resigning managers of the Company until the date of the present

resolutions for the accomplishment of their mandate.

<i>Fifth resolution

The Meeting resolved to appoint CCP III DK Germany Holding S.à r.l., a private limited liability company (société à

responsabilité limitée) organised and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered
office at 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies
(Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) under number B 161265 and with a share capital of EUR 12.562,50
as the managing director of the Company for an undetermined duration and with immediate effect.

<i>Sixth resolution

As a consequence of the above resolutions, the Meeting resolved to fully amend and restate the Articles of the Com-

pany in order to adapt them to the new legal form of the Company, without amendment to its essential elements, like
its corporate purpose.

Consequently, the twelve thousand five hundred (12,500) current shares are replaced by twelve thousand five hundred

(12,500) partnership interests with a nominal value of one Euro (EUR 1,-) per partnership interest.

Each Shareholder will receive one “S.N.C. partnership interest” against one “S.à r.l. share”.
The Shareholders acknowledge that the change of legal form of the Company shall not give rise to liquidation nor to

the creation of a new legal entity according to the Luxembourg law on commercial companies dated 10 August 1915 as
amended from time to time.

The Company's legal personality shall continue without interruption and will continue to exist and the rights and

obligations assumed by the Company under the form of a private limited liability company (société à responsabilité limitée)
will continue under the new form of the general partnership (S.N.C.).

The fully amended Articles shall read as follows:

<i>Table of contents clause

§ 1 Name of the partnership, registered office/main place of business
§ 2 Corporate purpose
§ 3 Partners, Partnership capital
§ 4 Partners’ accounts
§ 5 Management § 6 Partners’ meeting
§ 7 Partners’ resolutions
§ 8 Financial year, annual financial statements
§ 9 Distribution of profits
§ 10 Withdrawals
§ 11 Legal acts of disposition
§ 12 Duration of the Partnership, resignation/insolvency of a partner
§ 13 Exclusion of a partner

147009

L

U X E M B O U R G

§ 14 Severance payment
§ 15 Liquidation
§ 16 Final provisions

Partnership Agreement

§ 1. Name of the partnership, registered office/main place of business.
(1) A general partnership [Société en nom collectif (SNC)] is hereby established under the name Bayerische Archi-

tektenversorgung &amp; Co. SNC (hereinafter referred to as the “Partnership”).

(2) The Partnership’s registered office is in the city of Luxembourg.
The registered office may be moved to another location within the municipality by simple decision of the Partnership’s

Management. It may be moved to any other location in the Grand Duchy of Luxembourg by resolution of the partners’
meeting. Branches or other offices may be opened in both Luxembourg and abroad by decision of the Management.

In the event that developments of a political, economic, or social nature jeopardizing normal business activities at the

Partnership’s main place of business, or jeopardizing smooth dealings between this place of business and persons based
abroad, such as these activities and dealings have been determined by the Management, should have occurred or should
be imminent, then the main place of business may be temporarily moved abroad until normal conditions have been fully
restored; however, such temporary measures shall in no way affect the nationality of the Partnership which, irrespective
of the temporary relocation of the main place of business, shall continue to be a partnership incorporated under Lu-
xembourg law. Such temporary measures shall be taken by the Management and notified to all the parties concerned.

§ 2. Corporate purpose.
(1) The corporate purpose of the Partnership is the management of its own assets, namely exclusively the management

and administration of the premises belonging to the “Dieterich Karree” [a retail and residential complex] in Düsseldorf,
as well as their long-term management, in particular letting them. The Partnership is prohibited from engaging in any kind
of commercial activity.

(2) The Partnership is entitled to undertake any acts that are conducive to furthering this corporate purpose, whether

directly or indirectly. Equity participation in other undertakings is prohibited.

§ 3. Partners, Partnership capital.
(1) The Partnership capital amounts to EUR 12,500.00, divided into consecutively numbered shares with a nominal

value of one euro (EUR 1.00) per share.

(2) The following entities hold Partnership interests:
a) CCP III DK Germany Holding S.à r.l., a limited company [Gesellschaft mit beschränkter Haftung] under Luxembourg

law having its registered office at 16 avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg and registered in the Luxembourg Commercial
Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under number B 161265, whose Partnership interests amount to EUR
11,113.00 of the Partnership capital (corresponding to 88.9% of the total Partnership capital);

b) Bayerische Architektenversorgung, a public-law institution [Anstalt des Öffentlichen Rechts] having its registered

office in Munich, whose Partnership interests amount to EUR 750.00 of the capital (corresponding to 6% of the Partnership
capital); and

c) PAMERA 4. Investment GmbH &amp; Co. KG, having its registered office in Frankfurt am Main and registered in the

Commercial Register of Frankfurt am Main Local Court under number HRA 48063, whose Partnership interests amount
to EUR 637.00 of the capital (corresponding to 5.1% of the total Partnership capital).

§ 4. Partners’ accounts.
(1) A capital account, special reserves accounts, and loan accounts shall be maintained for the partners.
(2) The sole item that shall be posted to the capital account is the (mandatory) capital contribution made by the

partners.

(3) The items that shall be posted to each special reserves account maintained in connection with the Partnership

interests (“compte 115 pour apport en capitaux propres non rémunéré par des titres”) are any deposits by the respective
partner that are not to be allocated to the capital account. Each special reserves account shall be linked to the Partnership
interests of the respective partner making the deposits as of the time of the contribution. However, the amounts credited
to each special reserves account shall not entitle the respective partner to any voting rights or any additional rights with
respect to the distribution of profits. Deposits by a partner to the respective special reserves account and repayments
of deposits in a special reserves account to the respective partner must be approved by the partners by means of a simple
majority vote. The deposits in the special reserves accounts do not bear interest.

(4) Any partner may pay cash advances in favour of the Partnership into the respective loan account with the prior

approval of the other partners. The loan accounts are subject to interest at 1% p.a. on both debit and credit balances.
The interest payments are treated as expenses and earnings as far as the relationship between the partners is concerned.
Any amounts paid by a partner to the loan account in accordance with this provision shall not be deemed to be additional

147010

L

U X E M B O U R G

capital contributions, and the respective partner shall be treated as a creditor of the Partnership in relation to these
amounts and the interest due on them.

§ 5. Management.
(1) The Partnership shall be represented by a Managing Director. The Managing Director shall always represent the

Partnership by itself.

(2) CCP III DK Germany Holding S.à r.l. is the sole partner appointed as the Managing Director, hence it is authorized

and obliged to manage the Partnership.

(3) The Managing Director shall have the authority to undertake all acts of management and disposition, as well as to

make declarations, on behalf of the Partnership and in its interest unless such acts are reserved for the partners’ meeting
by law or under this Partnership Agreement.

(4) Execution of the following acts and legal transactions on behalf of the Partnership shall require the prior approval

of the partners’ meeting, whereby the approval of all the partners shall be necessary:

a) setting or changing the Partnership’s short-term, medium-term, and long-term business policy, particularly drawing

up or changing the economic plan for the Partnership as well as setting or changing its sales and marketing policy or pricing
policy;

b) drawing up or changing the financial plan, capital expenditure plan, or staffing plan for the coming financial year;
c) measures that have not been provided for in the financial and capital expenditure plans that have been drawn up,

particularly issuing bills of exchange and granting payment terms of more than three months;

d) taking up new business activities, and partially or completely abandoning existing business activities;
e) establishing or dissolving dependent or affiliated companies;
f) incorporating, restructuring, or abolishing/closing business divisions, permanent establishments or branches;
g) the change of legal form, merger, split-up or spin-off of the Partnership;
h) the admission of additional partners;
i) changes to capital accounts (but not changes to a special reserves account);
j) agreeing silent partnerships or issuing other profit entitlement rights (such as profit participation rights, participating

loans, preference shares, and such like);

k) legal transactions between the Partnership and one of its partners except for payments into a special reserves

account;

l) the acquisition, disposal, or encumbrance of participations in other undertakings, regardless of their legal form,

including silent participations, sub-participations, and participating interests held in trust, or assets constituting an under-
taking or part of an undertaking;

m) the acquisition, disposal, or encumbrance of real property, rights equivalent to real property or rights in real

property, or any undertaking to perform any such acts of disposition;

n) taking out and granting credit and loans, or providing securities;
o) assuming debt or assuming sureties, guarantees, or other liabilities on behalf of third parties that are outside the

scope of the Partnership’s normal course of business.

p) In relation to employees and workers of the Partnership:
aa) concluding, amending, or terminating employment contracts and service contracts that provide for a notice period

that is longer than the statutory notice period or that provide for profit sharing, sales commission, or an annual payment
(including special payments) of more than EUR 100,000.00;

bb) granting or withdrawing/revoking commercial powers of attorney [Prokuren] and general powers of attorney

[Generalhandlungsvollmachten];

q) concluding, amending, or terminating rental agreements, tenancy agreements, lease agreements, or other contracts

for the performance of continuing obligations that provide for a fixed term of more than one year or a notice period of
more than six months;

r) forward transactions for currencies, securities, or other goods or rights that are traded on stock exchanges;
s) concluding, amending, or terminating contracts between the Partnership and its Managing Director, members of

Management, or their immediate family members within the meaning of section 15 of the German Tax Code [Abgabe-
nordnung  (AO),  or  concluding,  amending,  or  terminating  contracts  with  undertakings  in  which  the  aforementioned
individuals are indirectly or directly involved;

t) concluding, amending, or terminating any other contracts that provide for a fixed term of more than one year or

that create obligations on the part of the Partnership amounting to more than EUR 5,000.00 a year;

u) instigating legal proceedings before national courts, authorities, or arbitral tribunals where the amount in dispute

is more than EUR 5,000.00, or agreeing to settlements during such proceedings;

v) transactions or measures outside the scope of the Partnership’s normal course of business; and
w) transactions or measures that have been declared by the partners’ meeting as requiring approval.

147011

L

U X E M B O U R G

(5) By contrast any of the Partnership’s acts and legal transactions that do not require approval by the partners are

excluded from the requirement for approval set out above, i.e.:

a) the sale and assignment of interests held by CCP III DK Germany Holding S.à r.l. in the Partnership to the partner

Bayerische Architektenversorgung; and

b) any measures or legal transactions in connection with the execution of a sale or assignment as specified in (5)a)

above that are necessary or appropriate to this end.

(6) If the performance of an act that is subject to approval in accordance with (4) above or a legal transaction that is

subject to approval in accordance with (4) above is urgent and it is not possible to obtain the requisite prior approval of
the partners’ meeting in time, then the act or legal transaction may also be performed without the consent of the partners’
meeting if this is necessary to avoid significant disadvantages for the Partnership. In such a case the Managing Director
must promptly inform the partners of the act or legal transaction that has been performed and the reason for its urgency.

(7) The partners’ meeting may specify additional acts and legal transactions that may only be undertaken with its

approval.

(8) The Managing Director shall be entitled to confer authority and special powers that are limited in time to any third

party that will accept such authority and special powers.

(9) The individual signature of the Managing Director, or the individual or joint signature of the person or persons

upon whom the Managing Director has conferred such a power of representation, shall be binding upon the Partnership.

(10) While exercising its office the Managing Director shall not enter into any personal commitments whatsoever in

respect of the commitments entered into by the Partnership. As the Partnership’s authorized representative it shall solely
assume liability for properly discharging its duties.

§ 6. Partners’ meeting.
(1) The partners’ meeting shall monitor the activities of Management without having a managerial role itself. The

partners’ meeting shall be fully empowered to undertake any acts on behalf of the Partnership that are in the Partnership’s
interests. In particular it shall decide on the appropriation and distribution of the Partnership’s profits as well as the legal
transactions under § 5(4).

(2) The ordinary partners’ meeting shall take place once a year at the Partnership’s registered office or another location

that shall be proposed by the Managing Director. In addition extraordinary partners’ meetings shall be convened if this
is necessary in the Partnership’s interest or if this is requested by a partner.

(3) They shall be convened by the Managing Director by means of a registered or personally acknowledged letter

stating  the  place,  date,  time,  and  agenda  with  at  least  two  weeks’  notice;  in  case  of  urgency  the  notice  period  may
reasonably be shortened to one week. For the purposes of calculating the notice period the date of posting and the date
of the partners’ meeting shall be excluded.

(4) No such convening notice is required if all the partners are present or represented at the partners’ meeting and

if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of the meeting. The notice may
be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail, of each partner.

Partners may only be represented in the partners’ meeting by another partner or by a third party that is professionally

bound to secrecy. The authorized representative must present the relevant power of attorney in written form, which
may be by fax or e-mail, at the start of the partners’ meeting. Each partner shall be entitled to call on the services of a
third party that is professionally bound to secrecy in the partners’ meeting for the purposes of obtaining advice. The
participation of another person as a partner’s representative or advisor shall require the unanimous approval of the
partners’ meeting.

(5) The Managing Director, or in the event of its absence the partner with the largest share of Partnership interests

(or its representative), shall chair the partners’ meeting (the “Chair”).

(6) For evidentiary purposes the Chair of the partners’ meeting shall take minutes of the partners’ meeting, which shall

record in particular the place and date of the meeting, the participants, the items on the agenda, the Chair’s verification
of the formalities of the convocation, and the presence of a quorum, all motions, results of votes, and all the partners’
resolutions that are adopted. The minutes must be signed by the Chair of the meeting and the Managing Director must
forward a copy of the minutes to each partner within one week of the partners’ meeting.

(7) The partners’ meeting shall constitute a quorum if all the partners have been duly summoned, and are present or

are duly represented. Should a partners’ meeting fail to constitute a quorum despite the parties having been duly sum-
moned, then another partners’ meeting with the same agenda must be convened in accordance with (3) above, whereby
the notice period shall be two days instead of the notice period that has to be observed under (3) above. This partners’
meeting shall be deemed to constitute a quorum regardless of the Partnership capital that is represented provided this
was pointed out in the convocation.

§ 7. Partners’ resolutions.
(1) Decisions to be made by the partners over the Partnership’s affairs shall be taken in the form of resolutions.

Resolutions shall be passed in partners’ meetings.

147012

L

U X E M B O U R G

(2) Each partnership interest of the Partnership capital shall entitle the holder to one vote (i.e. EUR 1 of partnership

interest entitles to one vote). Partners’ resolutions shall be adopted by simple majority of the votes cast unless this
Partnership Agreement or the law provides for a different majority. Changes to the Partnership Agreement shall require
the approval of all the partners. Partners shall also be entitled to vote in affairs relating to them. Abstentions shall not
count as votes cast.

(3) Unless this conflicts with mandatory statutory provisions, resolutions may also be passed, with the agreement of

all the partners, without adhering to the provisions for convening and notifying partners’ meetings that are laid down in
legislation and this Partnership Agreement and, contrary to sentence 2 in (1) above, outside the context of partners’
meetings and moreover in whatever form, including by means of any kind of telecommunications, by e-mail, and even by
a combination of forms. Participation in the passing of resolutions shall be deemed to constitute agreement with the form
of decision-making that has been selected. Resolutions that are not passed in a partners’ meeting must be recorded in a
log to which § 6(6) applies mutatis mutandis with the proviso that the manner of casting the individual votes must also
be described.

§ 8. Financial year, annual financial statements.
(1) The financial year shall be the calendar year.
(2) The Managing Director shall prepare the annual financial statements for the previous year within the statutory time

periods and forward it to the partners at least two weeks before the partners’ meeting to decide on whether to approve
it.

(3) Responsibility for approving the annual financial statements rests with the partners’ meeting.

§ 9. Distribution of profits.
(1) The partners shall participate in the profit remaining after taking account of the amounts that are treated as expenses

and earnings as far as the relationship between the partners is concerned, as well as in the losses, in proportion to their
share of the voting Partnership capital (capital accounts).

(2) The partners’ meeting shall decide on the appropriation of the profit subject to the approval of all the partners.

§ 10. Withdrawals. Withdrawals from the loan accounts shall only be permissible with the approval of the partners’

meeting. This shall require the approval of all the partners.

§ 11. Legal acts of disposition.
(1) With the exception of the provisions set out in § 5(5), acts of disposition performed by a partner over its Partnership

interests or parts thereof shall only be valid with the approval of all the partners. Any assignment of Partnership interests
must comply with the provisions of Article 1690 of the Luxembourg Civil Code.

(2) Partners that are subject to state supervision (such as insurance companies and banks) shall be free to dispose of

their share of the Partnership interests or to encumber it, and shall not require a partners’ resolution for this, if they are
assigning it in whole or in part to

a) an insurance company;
b) a financial institution;
c) a trust company;
d) a fund; or
e) any other company that issues or acquires loans, securities, or other financial stocks,
or invests in such a company, or if they are encumbering it in favour of any of the above.
(3) The preceding paragraphs (1) and (2) shall apply for granting sub-participations and/or trust arrangements in respect

of Partnership interests.

§ 12. Duration of the Partnership, resignation/insolvency of a partner.
(1) The Partnership is established for an indefinite period.
(2) It may be dissolved upon a unanimous resolution by all the partners. It may have commitments that extend beyond

its duration.

(3) Each partner may resign from the Partnership by giving notice three months before the end of the financial year,

but not before 31/12/2015. The resignation notice must be given by sending a registered letter to the Partnership and
the other partners.

(4) The right of any partner to resign for good cause shall remain unaffected.
(5) In the event of the resignation of a partner the Partnership shall not be dissolved but shall be continued by the

remaining partners with all its assets and liabilities under its previous name.

The partner that has resigned shall leave the Partnership upon the expiry of the notice period.
(6) The remaining partner or partners may also resign in the wake of the aforementioned resignation pursuant to (3)

above subject to giving notice two months before the expiry of the aforementioned notice period. Any partner that
subsequently resigns under these terms shall likewise leave the Partnership upon the expiry of the notice period. If all
the remaining partners, or all but one, should subsequently resign, then the Partnership shall be dissolved upon the expiry

147013

L

U X E M B O U R G

of the notice period; all the partners shall participate in its winding-up, regardless of whether they were the first to resign
or not.

(7) The creditors, legal successors, and heirs of the partners shall in no way be entitled to attach property or documents

belonging to the Partnership, take over the management of the Partnership, or call for its liquidation. Their rights shall
be confined to examining the annual financial statements and to their rights in the partners’ meeting of the Partnership.

(8)  The  death,  loss  of  legal  capacity,  insolvency,  or  illiquidity  of  a  partner  shall  not  result  in  the  cessation  of  the

Partnership. The partner concerned shall leave the Partnership. The Partnership shall be continued by the remaining
partners with all its assets and liabilities under its previous name.

(9) Partners leaving the Partnership shall receive a severance payment pursuant to § 14 of this Partnership Agreement.
(10) Any partner giving its resignation hereby agrees that the remaining partners shall be entitled to admit a new

partner after the resigning partner has given notice, but before it has left, without the resigning partner’s approval being
required. The value of the departing partner’s Partnership interests may not be reduced by the acceding partner.

§ 13. Exclusion of a partner.
(1) A partner may be excluded from the Partnership by resolution of the partners’ meeting in the event of serious and

persistent disagreement or a rift. This shall be the case in particular if:

the share of the participating interests of a creditor of the partner is attached on the basis of a judgment that is not

just provisionally enforceable or is otherwise judicially enforced in its favor, and such attachment or enforcement measure
is not rescinded within two months of serving notice of the attachment order to the Partnership or by the start of the
enforcement measure or, at the latest, by the time the share is realized;

a) insolvency proceedings (or similar proceedings) are opened over a partner’s assets, or the opening of insolvency

proceedings over a partner’s assets is rejected due to a lack of assets, or the partner has to affirm the accuracy of its
assets by means of an affidavit;

b) the partner is obstructing the Partnership’s capacity to act through its behaviour or in some other way without any

prospect of a remedy.

(2) After the partner concerned has been heard by the partners’ meeting the resolution to exclude the partner shall

be adopted by simple majority. The partner that is to be excluded pursuant to (1) above shall not be entitled to take part
in the voting.

(3) The partner concerned shall leave the Partnership upon receiving the resolution irrespective of the mandatory

severance payment in accordance with § 14.

(4) In the event of the exclusion of a partner the Partnership shall not be dissolved but shall be continued by the

remaining partners with all its assets and liabilities under its previous name.

(5) Instead of exclusion the partners may resolve, by at least 75% of the votes, that the partner concerned must assign

its share of the Partnership interests to a person that is to be named in the resolution and that is prepared to accept it.
In such a case the Partnership and the third party shall be jointly and severally liable for payment of the purchase price,
the amount and due date of which shall also be governed by the provisions on the severance payment (§ 14) mutatis
mutandis.

§ 14. Severance payment.
(1) In the event of the exclusion of a partner or alternatively the aforementioned assignment decided by resolution,

the partner concerned shall receive from the Partnership (in the case of exclusion) or from the beneficiary of the as-
signment (in the case of assignment) a severance payment in accordance with the following provisions:

a) The severance payment shall be in cash. It shall settle the relevant share of participating interests as well as any

claims based on it, including where it is linked to hidden reserves, goodwill, pending transactions of the Partnership, or
future profits of the Partnership.

b) The severance pay shall be determined and approved on the day of departure. It shall be calculated on the basis of

the fair market value of the departing partner’s share of the Partnership’s assets in accordance with the following principles:

- An interim balance sheet is to be prepared on the departure date at the expense of the Partnership.
- If the departure date is at the end of the financial year then the annual financial statements, approved by the partners,

shall be used instead, unless the provisions below stipulate otherwise.

- If the departure date does not coincide with a balance sheet date, then the interim balance sheet shall be based on

the values in the annual financial statements determined by the partners on the last balance sheet date prior to the date
of assignment; these values shall be updated on the assignment date. Deposits made after the departure date shall be
added, withdrawals shall be deducted.

- For the purposes of calculating the severance pay all credits in special reserves accounts shall be notionally treated

as liabilities of the Partnership and offset, thereby reducing the assets.

- Real estate held by the Partnership shall be offset at its fair market value instead of its book value.
c) The equity capital determined in accordance with the interim balance sheet multiplied by the percentage of the

departing partner’s share of the total capital of the Partnership (solely the percentage in the capital accounts, without

147014

L

U X E M B O U R G

taking account of the special reserves account or the loan account, shall be relevant) shall constitute the departing partner’s
share of the Partnership’s assets. This amount plus the credit in the special reserves account to be apportioned to the
departing partner’s share of the Partnership’s interests shall equal the severance pay credit.

If the partner is being excluded from the Partnership pursuant to § 13 then this partner shall only be entitled to

severance pay based on the book value of its participation. This shall be calculated on the basis of the credit in the capital
account maintained for it plus the credit in the special reserves account to be apportioned to the departing partner’s
share of the Partnership’s interests.

d) The severance pay shall be due to be paid immediately and shall be payable without the accrual of interest within a

period of four (4) months after the partner’s departure.

e) The severance pay shall also constitute compensation for the departing partner’s share of the current profits for

any financial year in which the partner leaves part way through the year. The departing partner shall not participate in
the profit and loss arising from any transactions that are pending at the time of its departure.

(2) The departing partner may not request any provision of security.
(3) Any credit in the loan account shall be paid to the partner immediately after its departure and any debit balance

shall be immediately settled by the partner.

(4) Any subsequent changes to the annual financial statements as a result of external tax audits or for any other reasons

shall not affect the severance pay.

(5) Should the parties fail to agree on the severance pay credit that is to be determined then a certified public auditor,

acting as an arbitrator, shall decide on the contentious points and such decisions shall be binding upon the parties. The
arbitrator shall be appointed at the request of one of the parties, unless the partners have come to an agreement within
a week of such a request, by the German Institute of Public Auditors [Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)]. The arbitrator
shall also decide on the costs of its services, which shall be in proportion to the extent to which each party prevails.

§ 15. Liquidation.
(1) After the Partnership has been dissolved it shall be wound up. The liquidator shall be the Managing Director that

was in office at the time of the dissolution.

(2) Any surplus left over after the Partnership has been wound up in full shall be allocated to the partners in proportion

to their share of the Partnership capital.

§ 16. Final provisions.
(1) Should any individual provisions in this Partnership Agreement be or become invalid or inapplicable, or should

there be a legal loophole in this Partnership Agreement, the validity of the remaining provisions shall not be affected
thereby. An appropriate provision, which, as far as is legally possible, most closely corresponds to what the partners
intended or would have intended in keeping with the spirit and purpose of this Partnership Agreement if they had con-
sidered the point, shall replace the invalid or inapplicable provision or fill the legal loophole. The same shall apply to the
severance pay that is owed pursuant to § 14.

(2) Any changes or additions to this Partnership Agreement, as well as the cancellation thereof, shall require the written

form.

(3) Each partner may request information in relation to the Partnership’s affairs, and may inspect the Partnership’s

books and documents at the Partnership’s business premises. The purpose of the inspection shall determine the content
and scope of the right of inspection. The other partners must be protected against any risk of the partner carrying out
the inspection becoming aware of their personal data (data protection).

(4) The partners may exercise the right to information and right of control themselves, or have such rights exercised

by an expert that is professionally bound to secrecy (such as a lawyer, tax advisor or certified public accountant/auditor),
at their own expense.

(5) All the partners shall maintain the secrecy of the Partnership’s confidential information and business secrets vis-à-

vis third parties.

(6) The partners are not bound by a non-compete obligation under this Partnership Agreement.
(7) This Partnership Agreement shall be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.

<i>Costs and expenses

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it

by reason of the present deed are assessed at EUR 1,750.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a German version; on request of the appearing party and in case of divergences between the English
and the German text, the English version will prevail.

147015

L

U X E M B O U R G

The document having been read to the proxyholder(s) of the appearing parties known to the notary by her name, first

name, civil status and residence, the proxyholder of the appearing parties signed together with the notary the present
deed.

The german translation follows:

Im Jahre zweitausendundvierzehn, am sechsundzwanzigsten August,
Vor Uns, dem unterzeichnenden Notar Martine SCHAEFFER, Notar, mit Amtssitz in Luxemburg,
würde eine außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschafter, der "CCP III DK Germany S.à r.l.", eine nach

Luxemburger Recht gegründete Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), mit Geschäfts-
anschrift in 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, mit einem Gesellschaftskapital in Höhe
von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister eingetragen (Re-
gistre  de  Commerce  et  des  Sociétés  Luxembourg)  unter  Sektion  B  mit  der  Nummer  161.296  (die  "Gesellschaft"),
abgehalten.

Die Gesellschaft wurde gemäß notarieller Beurkundung vom 30. Mai 2011, vor Maître Martine SCHAEFFER, Notarin,

mit Amtssitz in Luxemburg, gegründet, und im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 1859
Seite 89215 vom 12. August 2011, veröffentlicht (die "Satzung"). Die Satzung wurde seit der Gründung der Gesellschaft
nicht abgeändert.

Der Vorsitzende der Versammlung wird Frau Melissa KDYEM, avocat à la cour.
Der Vorsitzende ernennt als Schriftführer Frau Franziska STAHLBERG, Rechtsanwältin.
Die Versammlung wählt als Stimmenzähler Frau Judit STERN, avocat à la cour.
Der Vorsitzende ersucht den Notar folgende Beschlüsse zu beurkunden:
I.- Die vertretenen Gesellschafter (die "Gesellschafter") und die Anzahl der von jedem von ihnen gehaltenen Anteile

sind auf einer Anwesenheitsliste festgehalten. Diese Liste und die Vollmachten, werden vom Notar und den anwesenden
Gesellschaftern unterschrieben, und werden zusammen mit dem Protokoll, dieser Urkunde als Anhang beigefügt.

II.- Wie aus der Anwesenheitsliste hervorgeht, sind die zwölftausandfünfhundert (12.500) Anteile in registrierter Form,

welche  das  gesammte  Kapital  der  Gesellschaft  repräsentieren,  allesamt  ordungsgemäß  vertreten,  so  dass  folglich  die
Versammlung ordungsgemäß gebildet wurde und rechtskräftig über alle Punkte der Tagesordnung, über welche die Ge-
sellschafter zuvor informiert wurden, entscheiden können.

III.- Die Tagesordnung der Hauptversammlung lautet wie folgt:
1. Verzicht auf Einberufungserfordernisse;
2. Die Gesellschaftsform von einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung ("société à responsabilité limitée" - S.à r.l.)

in eine offene Handelsgesellschaft ("société en nom collectif” - S.N.C.) zu ändern;

3. Infolge der Rechtsformänderung, Änderung der Firma der Gesellschaft in “Bayerische Architektenversorgung &amp; Co.

S.N.C.”;

4. Entlastung der ausscheidenenden Geschäftsführer der Gesellschaft;
5. Ernennung des Geschäftsführers der Bayerische Architektenversorgung &amp; Co. S.N.C.;
6. Infolge der voranstehenden Beschlüsse, die vollständige Erneuerung der Satzung der Gesellschaft, ohne die wesent-

lichen Eigenschaften zu verändern;

7. Sonstiges.
Diese Fakten wurden dargelegt und von der Versammlung als wahr anerkannt, woraufhin die Versammlung Folgendes

beschlossen hat:

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafter nehmen zur Kenntnis, dass die das gesamte Gesellschaftskapital repräsentieren, so dass die Ver-

sammlung  (die  "Versammlung")  wirksam  über  alle  Tagesordnungspunkte  befinden  kann,  welche  den  Gesellschaftern
bekannt sind. Die Gesellschafter beschliessen, auf jegliche Einberufungserfordernisse zu verzichten.

<i>Zweiter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt, die Gesellschaftsform von einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung ("société à

responsabilité limitée" - S.à r.l.) in eine offene Handelsgesellschaft (“société en nom collectif” - S.N.C.) zu ändern.

<i>Dritter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt, infolge der Rechtsformänderung, die Firma der Gesellschaft in "Bayerische Archi-

tektenversorgung &amp; Co. S.N.C." abzuändern.

<i>Vierter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt, die Geschäftsführer der Gesellschaft für die Ausübung ihres Amtes bis zum Tag

der vorliegenden Beschlüsse vollständig zu entlasten.

147016

L

U X E M B O U R G

<i>Fünfter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt, CCP III DK Germany Holding S.à r.l., eine nach Luxemburger Recht gegründete

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), mit Geschäftsanschrift in 16, avenue Pasteur,
L-2310 Luxemburg, im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister eingetragen (Registre de Commerce et des So-
ciétés  Luxembourg)  unter  der  Nummer  B  161.265  mit  einem  Gesellschaftskapital  in  Höhe  von  EUR  12.562,50  als
Geschäftsführer der Gesellschaft für unbestimmte Dauer und mit sofortiger Wirkung zu ernennen.

<i>Sechster Beschluss

Infolge der voranstehenden Beschlüsse, beschließt die Hauptversammlung, die Satzung der Gesellschaft vollständig

abzuändern und umzuformulieren, um sie der neuen Gesellschaftsform anzupassen, aber ohne die wesentlichen Eigen-
schaften wie den Gesellschaftszweck zu verändern.

Folglich werden die aktuellen zwölftausendfünfhundert (12.500) Anteile durch zwölftausendfünfhundert (12.500) Be-

teiligungen mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1,-) ersetzt.

Jeder Gesellschafter wird eine “S.N.C. Beteiligung” für einen "S.à r.l. Anteil" bekommen.
Die Gesellschafter bestätigen, dass die Änderung der Gesellschaftsform, im Einklang mit dem Luxemburger Gesetz

über Handelsgesellschaften vom 10. August 1915, in jeweils abgeänderter Form, weder die bestehende Gesellschaft auf-
löst, noch eine neue Gesellschaft begründet.

Die  Rechtspersönlichkeit  der  Gesellschaft  wird  ohne  Unterbrechnung  weiterbestehen,  und  auch  die  Rechte  und

Pflichten der Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) werden unter der neuen Form einer
offenen Handelsgesellschaft (S.N.C.) weiterbestehen.

Die geänderte Satzung wird wie folgt gefasst:

<i>Inhaltsverzeichnis Klausel

§ 1 Bezeichnung, Gesellschaftssitz
§ 2 Gegenstand des Unternehmens
§ 3 Gesellschafter, Gesellschaftskapital
§ 4 Gesellschafterkonten
§ 5 Geschäftsführung
§ 6 Gesellschafterversammlung
§ 7 Gesellschafterbeschlüsse
§ 8 Geschäftsjahr, Jahresabschluss
§ 9 Ergebnisverteilung
§ 10 Entnahmen
§ 11 Rechtsgeschäftliche Verfügungen
§ 12 Dauer der Gesellschaft, Kündigung oder Insolvenz eines Gesellschafters
§ 13 Ausschluss eines Gesellschafters
§ 14 Abfindung
§ 15 Liquidation
§ 16 Schlussbestimmungen

Gesellschaftsvertrag

§ 1. Bezeichnung, Gesellschaftssitz.
(1) Hiermit wird eine offene Handelsgesellschaft ("Société en nom collectif") unter der Firmenbezeichnung Bayerische

Architektenversorgung &amp; Co. SNC gegründet (nachstehend die "Gesellschaft").

(2) Der eingetragene Sitz der Gesellschaft ist in der Stadt Luxemburg.
Der Sitz kann durch einfachen Beschluss der Geschäftsführung der Gesellschaft an einen anderen Ort innerhalb der

Gemeinde  verlegt  werden.  Er  kann  durch  einen  Beschluss  der  Gesellschafterversammlung  an  jeden  anderen  Ort  im
Großherzogtum Luxemburg verlegt werden. Niederlassungen oder andere Büros können sowohl in Luxemburg als auch
im Ausland durch Beschluss der Geschäftsführung eröffnet werden.

Sollten sich Entwicklungen politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art zugetragen haben oder eminent werden, die

die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz und Personen
im Ausland, wie durch die Geschäftsführung bestimmt, gefährden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur
völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden; diese vorübergehenden Maßnahmen be-
treffen jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft, welche ungeachtet der vorübergehenden Verlegung des
Gesellschaftssitzes, eine luxemburgische Gesellschaft bleibt. Diese vorübergehenden Maßnahmen werden von der Ge-
schäftsführung getroffen und allen betroffenen Parteien mitgeteilt.

147017

L

U X E M B O U R G

§ 2. Gegenstand des Unternehmens.
(1) Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft ist die Verwaltung eigenen Vermögens, nämlich ausschließlich die

Verwaltung und Bewirtschaftung der zum Dieterich Karree in Düsseldorf gehörenden Grundstücke, und deren langfristige
Verwaltung, insbesondere dessen Vermietung. Der Gesellschaft ist jegliche gewerbliche Betätigung untersagt.

(2) Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen berechtigt, die unmittelbar oder mittelbar diesem Gegenstand des Un-

ternehmens zu dienen geeignet sind. Die Beteiligung an anderen Unternehmen ist untersagt.

§ 3. Gesellschafter, Gesellschaftskapital.
(1) Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 12.500,00, eingeteilt in 12.500 durchnummerierte Gesellschaftsanteile mit

einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1).

(2) An der Gesellschaft sind beteiligt
a) CCP III DK Germany Holding S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée)

nach Luxemburger Recht mit Sitz in 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und
Gesellschaftsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) unter der Nummer B 161265 mit einem Anteil am Ge-
sellschaftskapital in Höhe von EUR 11.113,00 (entspricht 88,9 % am gesamten Gesellschaftskapital);

b) Bayerische Architektenversorgung, Anstalt des Öffentlichen Rechts mit Sitz in München, vertreten durch die Ba-

yerische Versorgungskammer mit Sitz in Arabellastraße 31, D-81925 München, mit einem Anteil am Gesellschaftskapital
in Höhe von EUR 750,00 (entspricht 6 % am gesamten Gesellschaftskapitals) und

c) PAMERA 4. Investment GmbH &amp; Co. KG, mit Sitz in Wöhlerstr. 10, D-60323 Frankfurt am Main und eingetragen

im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRA 48063 mit einem Anteil am Gesellschaftskapital in
Höhe von EUR 637,00 (entspricht 5,1 % am gesamten Gesellschaftskapitals).

§ 4. Gesellschafterkonten.
(1) Für die Gesellschafter werden ein Kapitalkonto, Sonderrücklagenkonten und Darlehenskonten geführt.
(2)  Auf  dem  Kapitalkonto  wird  ausschließlich  die  von  den  Gesellschaftern  geleistete  Kapitaleinlage  (Pflichteinlage)

gebucht.

(3) Auf dem in Verbindung mit den Gesellschaftsanteilen geführten Sonderrücklagenkonto („compte 115 pour apport

en capitaux propres non rémunéré par des titres“) sind Einlagen des den jeweiligen Gesellschaftsanteil haltenden Gesell-
schafters  zu  buchen,  die  nicht  dem  Kapitalkonto  zuzurechnen  sind.  Das  jeweilige  Sonderrücklagenkonto  ist  mit  den
Gesellschaftsanteilen des die Einlagen einbringenden Gesellschafters zum Zeitpunkt der Einbringung verbunden. Die auf
dem jeweiligen Sonderrücklagenkonto verbuchten Beträge räumen dem betroffenen Gesellschafter jedoch keine Stimm-
rechte oder zusätzliche Rechte bei der Ergebnisverteilung ein. Einlagen eines Gesellschafters auf das Sonderrücklagen-
konto und Rückzahlungen von Einlagen auf dem Sonderrücklagenkonto an einen Gesellschafter bedürfen der Zustimmung
der Gesellschafter mit einfacher Mehrheit. Die Einlagen auf dem Sonderrücklagenkonto sind unverzinslich.

(4) Auf das Darlehenskonto kann jeder Gesellschafter, mit der vorherigen Zustimmung der anderen Gesellschafter,

Vorschüsse in Barmitteln zugunsten der Gesellschaft leisten. Die Darlehenskonten sind im Soll und Haben mit 1 % p.a.
zu verzinsen. Die Zinsen gelten im Verhältnis der Gesellschafter zueinander als Aufwand bzw. Ertrag. Die von einem
Gesellschafter gemäß dieser Regelung auf das Darlehenskonto geleisteten Beträge werden nicht als weitere Kapitalein-
lagen erachtet und der Gesellschafter wird in Bezug auf diese Beträge und die darauf fälligen Zinsen als Gläubiger der
Gesellschaft behandelt.

§ 5. Geschäftsführung.
(1) Die Gesellschaft wird durch einen Geschäftsführer vertreten. Der Geschäftsführer vertritt die Gesellschaft stets

allein.

(2) Die CCP III DK Germany Holding S.à r.l. ist als einziger Gesellschafter als Geschäftsführer bestellt, und somit zur

Geschäftsführung berechtigt und verpflichtet.

(3) Der Geschäftsführer ist berechtigt, sämtliche Verwaltungs- und Verfügungshandlungen sowie Erklärungen im Na-

men der Gesellschaft und in deren Interesse vorzunehmen bzw. abzugeben, soweit diese nicht nach Gesetz oder diesem
Gesellschaftsvertrag der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind.

(4) Folgende Handlungen und Rechtsgeschäfte für die Gesellschaft bedürfen der vorherigen Zustimmung der Gesell-

schafterversammlung, wobei hierfür die Zustimmung aller Gesellschafter erforderlich ist:

a) Festlegung oder Änderung der lang-, mittel- und kurzfristigen Geschäftspolitik der Gesellschaft, insbesondere Fest-

stellung oder Änderung des Wirtschaftsplans für die Gesellschaft sowie Festlegung oder Änderung der Vertriebs- oder
Preispolitik;

b) Feststellung oder Änderung des Finanz-, Investitions- oder Personalplans für das bevorstehende Geschäftsjahr;
c) Maßnahmen, die im festgestellten Finanz- und Investitionsplan nicht vorgesehen sind, insbesondere die Begebung

von Wechseln und die Einräumung von Zahlungszielen von mehr als drei Monaten;

d) Aufnahme neuer Geschäftstätigkeiten sowie teilweise oder vollständige Aufgabe bestehender Geschäftstätigkeiten;
e) Gründung oder Auflösung von abhängigen oder verbundenen Gesellschaften;

147018

L

U X E M B O U R G

f) Errichtung, wesentliche Umgestaltung oder Aufhebung/Schließung von Unternehmenszweigen, Betriebsstätten oder

Zweigniederlassungen;

g) die Umwandlung, Verschmelzung, Aufspaltung oder Abspaltung der Gesellschaft;
h) die Aufnahme weiterer Gesellschafter;
i) die Veränderung der Kapitalkonten (nicht dagegen des Sonderücklagenkontos);
j) die Vereinbarung von stillen Beteiligungen oder Begebung sonstiger Gewinnbezugsrechte (etwa Genussrechte, par-

tiarische Darlehen, Vorzugsaktien o.ä.);

k) Rechtsgeschäfte zwischen der Gesellschaft und einem ihrer Gesellschafter mit Ausnahme von Einzahlungen auf das

Sonderücklagenkonto;

l) Erwerb, Veräußerung oder Belastung von Beteiligungen an anderen Unternehmen, gleich welcher Rechtsform, ein-

schließlich stiller Beteiligungen, Unterbeteiligungen und treuhänderischer Beteiligungen, oder von Vermögensgegenstän-
den, die ein Unternehmen oder einen Unternehmensteil ausmachen;

m) Erwerb, Veräußerung oder Belastung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten oder Rechten an Grund-

stücken sowie Verpflichtung zur Vornahme solcher Verfügungen;

n) Aufnahme und Gewährung von Krediten und Darlehen sowie Gewährung von Sicherheiten;
o) Schuldübernahmen sowie Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder sonstigen Haftungen für Dritte, die über

den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb der Gesellschaft hinausgehen.

p) im Hinblick auf Arbeitnehmer und Mitarbeiter der Gesellschaft:
aa) Abschluss, Änderung oder Beendigung von Anstellungs- und Dienstverträgen, die eine längere als die gesetzliche

Kündigungsfrist oder eine Gewinn- oder Umsatzbeteiligung oder eine jährliche Vergütung (einschließlich Sonderzahlun-
gen) von mehr als EUR 100.000,00 vorsehen;

bb) Erteilung oder Entzug/Widerruf von Prokuren und Generalhandlungsvollmachten;
q) Abschluss, Änderung oder Beendigung von Miet-, Pacht-, Leasingoder sonstigen Dauerschuldverträgen, die eine

feste Laufzeit von mehr als einem Jahr oder eine Kündigungsfrist von mehr als sechs Monaten vorsehen;

r) Termingeschäfte über Devisen, Wertpapiere oder andere an Börsen gehandelte Waren oder Rechte;
s) Abschluss, Änderung oder Beendigung von Verträgen der Gesellschaft mit dem Geschäftsführer, Mitgliedern der

Geschäftsführung oder deren Angehörigen im Sinne von § 15 Abgabenordnung (AO) sowie Abschluss, Änderung oder
Beendigung von Verträgen mit Unternehmen, an denen die vorgenannten Personen mittelbar oder unmittelbar beteiligt
sind;

t) Abschluss, Änderung oder Beendigung von sonstigen Verträgen, die eine feste Laufzeit von mehr als einem Jahr

vorsehen oder Verpflichtungen der Gesellschaft von jährlich mehr als EUR 5.000,00 begründen;

u) Einleitung von Verfahren vor staatlichen Gerichten, Behörden oder Schiedsgerichten mit einem Streitwert von mehr

als EUR 5.000,00 sowie Abschluss von Vergleichen in solchen Verfahren;

v) Geschäfte oder Maßnahmen, die über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb der Gesellschaft hinausgehen; und
w) Geschäfte oder Maßnahmen, welche die Gesellschafterversammlung für zustimmungsbedürftig erklärt hat.
(5) Von dem vorstehenden Zustimmungserfordernis ausgenommen sind dagegen sämtliche Handlungen und Rechts-

geschäfte der Gesellschaft, die keiner Zustimmung der Gesellschafter bedürfen:

a) Verkauf und Abtretung über den Gesellschaftsanteil der CCP III DK Germany Holding S.à r.l. an der Gesellschaft

an den Gesellschafter Bayerische Architektenversorgung; und

b) sämtliche Maßnahmen und Rechtsgeschäfte, die zur Durchführung des unter Absatz (5)a) aufgeführten Verkaufs und

der Abtretung im Zusammenhang stehen und hierfür erforderlich und/ oder zweckmäßig sind.

(6) Ist die Vornahme einer nach Absatz (4) zustimmungspflichtigen Handlung oder eines nach Absatz (4) zustimmungs-

pflichtigen Rechtsgeschäfts eilbedürftig und ist es nicht möglich, die erforderliche Zustimmung der Gesellschafterver-
sammlung  rechtzeitig  vorab  einzuholen,  so  darf  die  Handlung  oder  das  Rechtsgeschäft  auch  ohne  Einwilligung  der
Gesellschafterversammlung vorgenommen werden, wenn dies notwendig ist, um wesentliche Nachteile für die Gesell-
schaft  abzuwenden.  In  diesem  Fall  hat  der  Geschäftsführer  die  Gesellschafter  unverzüglich  über  die  vorgenommene
Handlung oder das vorgenommene Rechtsgeschäft und den Grund der Eilbedürftigkeit zu unterrichten.

(7) Die Gesellschafterversammlung kann weitere Handlungen und Rechtsgeschäfte bestimmen, die nur mit ihrer Zu-

stimmung vorgenommen werden dürfen.

(8) Der Geschäftsführer ist berechtigt, jegliche Befugnisse und Sondervollmachten zeitlich begrenzt an jeden Dritten

zu übertragen, der diese Befugnisse und Sondervollmachten annimmt.

(9) Die Gesellschaft wird durch die Einzelschrift des Geschäftsführers oder die Einzel- oder gemeinsame Unterschrift

der Person oder Personen welcher/n solche Vertretungsmacht vom Geschäftsführer übertragen werden wird, verpflich-
tet.

(10) Der Geschäftsführer geht in der Ausübung seines Amts keinerlei persönliche Verpflichtungen hinsichtlich der von

der Gesellschaft eingegangenen Verbindlichkeiten ein. Als Bevollmächtigter der Gesellschaft haftet er lediglich für die
ordnungsgemäße Ausführung seiner Pflichten.

147019

L

U X E M B O U R G

§ 6. Gesellschafterversammlung.
(1) Die Gesellschafterversammlung überwacht die Tätigkeit der Geschäftsführung, ohne selbst geschäftsführend tätig

zu sein. Die Gesellschafterversammlung verfügt über sämtliche Befugnisse, alle Handlungen für die Gesellschaft vorzu-
nehmen, die im Interesse der Gesellschaft liegen. Sie beschließt insbesondere über die Verwendung und Verteilung des
Ergebnisses der Gesellschaft sowie der Rechtsgeschäfte unter § 5(4).

(2) Die ordentliche Gesellschafterversammlung findet jährlich einmal am Sitz der Gesellschaft oder einem anderen von

dem Geschäftsführer vorzuschlagenden Ort statt. Darüber hinaus sind außerordentliche Versammlungen einzuberufen,
wenn dies im Interesse der Gesellschaft erforderlich ist oder von einem Gesellschafter verlangt wird.

(3) Die Einberufung erfolgt durch den Geschäftsführer mittels eingeschriebenen oder persönlich quittierten Briefes

unter Angabe von Ort, Tag, Zeit und Tagesordnung mit einer Frist von mindestens 2 Wochen; bei Eilbedürftigkeit kann
die Frist angemessen bis auf eine Woche verkürzt werden. Für die Fristberechnung werden der Tag der Aufgabe zur Post
und der Tag der Gesellschafterversammlung nicht mitgezählt.

(4) Eine formelle Einberufung ensprechend § 6(3) ist nicht erforderlich, sofern alle Gesellschafter bei der Gesellschaf-

terversammlung anwesend oder vertreten sind and bestätigen, dass sie ausreichend informiert wurden und volle Kenntnis
der Tagesordnung haben. Auf eine formelle Einberufung entsprechend § 6(3) können die Gesellschafter verzichten; hierfür
ist der schriftliche Verzicht eines jeden Gesellschafters erforderlich, sei es per Post, Telegramm, Fax oder E-Mail.

(5) Ein Gesellschafter kann in der Gesellschafterversammlung nur durch einen anderen Gesellschafter oder einen

beruflich zur Verschwiegenheit verpflichteten Dritten vertreten werden. Der Bevollmächtigte hat zu Beginn der Gesell-
schafterversammlung eine Vollmacht in Schriftform, Fax oder EMail vorzulegen. Jeder Gesellschafter ist berechtigt, in der
Gesellschafterversammlung zu seiner Beratung einen beruflich zur Verschwiegenheit verpflichteten Dritten hinzuzuziehen.
Die Teilnahme anderer Personen als Vertreter oder Beistand eines Gesellschafters bedarf der einstimmigen Zustimmung
der Gesellschafterversammlung.

(6) Die Leitung der Gesellschafterversammlung ("Leitung") übernimmt der Geschäftsführer und im Falle seiner Ab-

wesenheit der Gesellschafter (bzw. dessen Vertreter) mit dem größten Anteil am Gesellschaftskapital.

(7) Der Versammlungsleiter hat über die Gesellschafterversammlung zu Beweiszwecken ein Protokoll anzufertigen, in

welchem insbesondere Ort und Tag der Versammlung, die Teilnehmer, die Gegenstände der Tagesordnung, die Fest-
stellung  des  Versammlungsleiters  über  die  Förmlichkeiten  der  Einberufung  und  die  Beschlussfähigkeit,  alle  Anträge,
Ergebnisse der Abstimmungen sowie die gefassten Gesellschafterbeschlüsse anzugeben sind. Das Protokoll ist vom Ver-
sammlungsleiter zu unterzeichnen und der Geschäftsführer hat das Protokoll jedem Gesellschafter innerhalb von einer
Woche nach der Gesellschafterversammlung in Abschrift zu übermitteln.

(8) Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn alle Gesellschafter ordnungsgemäß geladen und anwesend

oder ordnungsgemäß vertreten sind. Ist eine Gesellschafterversammlung trotz ordnungsgemäßer Ladung nicht beschluss-
fähig,  ist  unverzüglich  eine  neue  Gesellschafterversammlung  mit  der  gleichen  Tagesordnung  in  Übereinstimmung  mit
Absatz (3) einzuberufen, wobei anstelle der nach Absatz (3) einzuhaltenden Frist diese Frist zwei Tage beträgt. Diese
Gesellschafterversammlung ist ohne Rücksicht auf das vertretene Gesellschaftskapital beschlussfähig, wenn hierauf in der
Einberufung hingewiesen wurde.

§ 7. Gesellschafterbeschlüsse.
(1) Die von den Gesellschaftern in Angelegenheiten der Gesellschaft zu treffenden Entscheidungen erfolgen durch

Beschlüsse. Die Beschlüsse werden in Gesellschafterversammlungen gefasst.

(2) Jeder volle Euro eines Gesellschaftsanteils berechtigt zur Abgabe einer Stimme. Gesellschafterbeschlüsse werden

mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, soweit nicht dieser Gesellschaftsvertrag oder das Gesetz eine
andere Mehrheit vorsehen. Änderungen des Gesellschaftsvertrages bedürfen der Zustimmung aller Gesellschafter. Die
Gesellschafter sind auch in eigenen Angelegenheiten stimmberechtigt. Stimmenthaltungen gelten nicht als abgegebene
Stimmen.

(3) Sofern keine zwingenden gesetzlichen Bestimmungen entgegenstehen, können im Einverständnis aller Gesellschafter

Beschlüsse auch ohne Einhaltung der gesetzlichen und gesellschaftsvertraglichen Vorschriften für die Einberufung und
Ankündigung von Gesellschafterversammlungen sowie abweichend von Absatz (1) Satz 2 auch außerhalb von Gesell-
schafterversammlungen und darüber hinaus in jeder beliebigen Form, auch im Wege jeder Art von Telekommunikation,
mittels E-Mail und auch in gemischter Form gefasst werden. Die Teilnahme an der Beschlussfassung gilt als Einverständnis
mit der gewählten Beschlussform. Außerhalb einer Gesellschafterversammlung gefasste Beschlüsse sind in einem Protokoll
schriftlich niederzulegen, für das § 6(6) entsprechend gilt mit der Maßgabe, dass auch die Art und Weise der einzelnen
Stimmabgaben wiedergegeben wird.

§ 8. Geschäftsjahr, Jahresabschluss.
(1) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
(2) Der Geschäftsführer hat den Jahresabschluss für das vorangegangene Geschäftsjahr innerhalb der gesetzlichen

Fristen  aufzustellen  und  mindestens  zwei  Wochen  vor  der  Gesellschafterversammlung,  die  über  seine  Genehmigung
entscheidet, den Gesellschaftern zu übermitteln.

(3) Die Feststellung des Jahresabschlusses obliegt der Gesellschafterversammlung.

147020

L

U X E M B O U R G

§ 9. Ergebnisverteilung.
(1) An dem Gewinn, der nach Berücksichtigung der Beträge verbleibt, die im Verhältnis der Gesellschafter zueinander

als Aufwand bzw. Ertrag behandelt werden, sowie an dem Verlust nehmen die Gesellschafter im Verhältnis ihres Anteils
am stimmberechtigten Gesellschaftskapital (Kapitalkonten) teil.

(2) Über die Gewinnverwendung beschließt die Gesellschafterversammlung unter Zustimmung aller Gesellschafter.

§ 10. Entnahmen.  Entnahmen  aus  den  Darlehenskonten  sind  nur  mit  Zustimmung  der  Gesellschafterversammlung

zulässig. Hierfür ist die Zustimmung aller Gesellschafter erforderlich.

§ 11. Rechtsgeschäftliche Verfügungen.
(1) Mit Ausnahme der Regelungen unter § 5(5) sind rechtsgeschäftliche Verfügungen eines Gesellschafters über seinen

Gesellschaftsanteil oder Teile davon nur wirksam mit Zustimmung aller Gesellschafter. Jede Abtretung von Gesellschafts-
anteilen muss die Bestimmungen des Artikels 1690 des Zivilgesetzbuches von Luxemburg beachten.

(2) Gesellschafter, die einer staatlichen Aufsicht unterliegen (wie z.B. Versicherer, Banken) sind in der Verfügung über

ihren Anteil oder dessen Belastung frei und bedürfen keines Gesellschafterbeschlusses, soweit sie ihren Anteil ganz oder
teilweise auf

a) eine Versicherung;
b) ein Finanzinstitut;
c) eine Treuhandgesellschaft;
d) einen Fonds; oder
e) eine andere Gesellschaft, die Darlehen, Wertpapiere oder andere Finanzwerte ausgibt, erwirbt oder in eine derartige

Gesellschaft investiert, übertragen oder zu deren Gunsten belasten.

(3) Vorstehender Absätze (1) und (2) gelten für die Einräumung von Unterbeteiligungen bzw. Treuhandverhältnissen

an Gesellschaftsanteilen entsprechend.

§ 12. Dauer der Gesellschaft, Kündigung oder Insolvenz eines Gesellschafters.
(1) Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.
(2) Die Gesellschaft kann durch einstimmigen Beschluss aller Gesellschafter aufgelöst werden. Sie kann Verpflichtungen

haben, die ihre Dauer überschreiten.

(3) Jeder Gesellschafter kann das Gesellschaftsverhältnis mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Geschäfts-

jahres, erstmals jedoch zum 31.12.2015 kündigen. Die Kündigung hat durch eingeschriebenen Brief an die Gesellschaft
und die übrigen Gesellschafter zu erfolgen.

(4) Das Recht jedes Gesellschafters zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.
(5) Im Falle der Kündigung eines Gesellschafters wird die Gesellschaft nicht aufgelöst, sondern von den übrigen Ge-

sellschaftern mit allen Aktiven und Passiven unter der bisherigen Firma fortgesetzt. Der Gesellschafter, der gekündigt hat,
scheidet mit Ablauf der Kündigungsfrist aus der Gesellschaft aus.

(6) Der oder die verbleibenden Gesellschafter können sich der Kündigung nach Absatz (3) mit einer Frist von zwei

Monaten zum Ablauf der Kündigungsfrist anschließen. Die Gesellschafter, die eine solche Anschlusskündigung erklären,
scheiden ebenfalls mit Ablauf der Kündigungsfrist aus der Gesellschaft aus. Sollten sich alle verbleibenden Gesellschafter
oder alle bis auf einen der Kündigung anschließen, wird die Gesellschaft zum Ablauf der Kündigungsfrist aufgelöst; an der
Abwicklung nehmen alle Gesellschafter - trotz Kündigung oder Anschlusskündigung - teil.

(7) Die Gläubiger, Rechtsnachfolger und Erben der Gesellschafter sind in keiner Weise berechtigt, Güter und Doku-

mente der Gesellschaft zu verpfänden, die Geschäftsführung der Gesellschaft zu übernehmen oder die Liquidation der
Gesellschaft zu fordern. Ihre Rechte beschränken sich auf die Prüfung der Jahresabschlüsse und ihre Rechte in der Ge-
sellschafterversammlung der Gesellschaft.

(8) Der Tod bzw. der Verlust der Geschäftsfähigkeit, die Insolvenz oder Zahlungsunfähigkeit eines der Gesellschafter

hat nicht die Beendigung der Gesellschaft zur Folge. Der betroffene Gesellschafter scheidet aus der Gesellschaft aus. Die
Gesellschaft wird von den übrigen Gesellschaftern mit allen Aktiven und Passiven unter der bisherigen Firma fortgesetzt.

(9) Gesellschafter, die aus der Gesellschaft ausscheiden, erhalten eine Abfindung nach § 14 dieses Gesellschaftsvert-

rages.

(10) Der kündigende Gesellschafter stimmt schon jetzt zu, dass die verbleibenden Gesellschafter berechtigt sind, nach

Kündigung, aber vor Ausscheiden des Kündigenden, einen neuen Gesellschafter aufzunehmen, ohne dass es der Zustim-
mung des kündigenden Gesellschafters bedarf. Durch den neu eintretenden Gesellschafter darf der Wert der Beteiligung
des ausscheidenden Gesellschafters nicht geschmälert werden.

§ 13. Ausschluss eines Gesellschafters.
(1) Ein Gesellschafter kann aus der Gesellschaft durch Beschluss der Gesellschafterversammlung ausgeschlossen wer-

den, wenn schwerwiegende und andauernde Uneinigkeit oder ein Zerwürfnis herrscht. Dies ist insbesondere der Fall,
wenn:

147021

L

U X E M B O U R G

a) der Gesellschaftsanteil von einem Gläubiger des Gesellschafters aufgrund eines nicht nur vorläufig vollstreckbaren

Titels gepfändet oder sonstwie in diesen vollstreckt wird und die Pfändung oder Vollstreckungsmaßnahme nicht innerhalb
von zwei Monaten nach Zustellung des Pfändungsbeschlusses an die Gesellschaft oder Beginn der Vollstreckungsmaß-
nahme, spätestens jedoch bis zur Verwertung des Gesellschaftsanteils, wieder aufgehoben wird;

b) über das Vermögen eines Gesellschafters ein Insolvenzverfahren (bzw. ein vergleichbares Verfahren) eröffnet wird

oder die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Gesellschafters mangels Masse abgelehnt wird oder
der Gesellschafter die Richtigkeit seines Vermögensverzeichnisses an Eides statt zu versichern hat;

c)  der  Gesellschafter  durch  sein  Verhalten  oder  in  sonstiger  Weise  die  Handlungsfähigkeit  der  Gesellschaft  ohne

Aussicht auf Abhilfe blockiert.

(2) Nach Anhörung des betroffenen Gesellschafters durch die Gesellschafterversammlung erfolgt die Beschlussfassung

über den Ausschluss mit einfacher Mehrheit. Dem Gesellschafter, der nach Absatz (1) ausgeschlossen werden soll, steht
bei der Abstimmung kein Stimmrecht zu.

(3) Der betroffene Gesellschafter scheidet unabhängig von der zwingenden Zahlung einer Abfindung gemäß § 14 mit

Zugang des Beschlusses aus der Gesellschaft aus.

(4) Im Falle des Ausschlusses eines Gesellschafters wird die Gesellschaft nicht aufgelöst, sondern von den übrigen

Gesellschaftern mit allen Aktiven und Passiven unter der bisherigen Firma fortgesetzt.

(5) Statt des Ausschlusses können die Gesellschafter mit 75% der Stimmen beschließen, dass der betroffene Gesell-

schafter seinen Gesellschaftsanteil auf eine im Beschluss zu nennende übernahmebereite Person zu übertragen hat. In
diesem Falle haftet die Gesellschaft neben dem Dritten gesamtschuldnerisch für die Zahlung des Kaufpreises, für dessen
Höhe und Fälligkeit die Vorschriften über die Abfindung (§ 14) entsprechend gelten.

§ 14. Abfindung.
(1) In den Fällen des Ausschlusses eines Gesellschafters oder der statt ihrer beschlossenen Übertragung erhält der

betroffene Gesellschafter von der Gesellschaft (im Fall des Ausschlusses) bzw. vom Abtretungsempfänger (im Fall der
Abtretung) eine Abfindung nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen:

a) Die Abfindung ist eine Geldabfindung. Mit ihr werden der betroffene Gesellschaftsanteil sowie alle auf ihm beruh-

enden Ansprüche abgefunden, auch soweit sie mit stillen Reserven, einem Firmen- oder Geschäftswert, schwebenden
Geschäften der Gesellschaft oder künftigen Gewinnen der Gesellschaft zusammenhängen.

b) Die Abfindung ist auf den Tag des Ausscheidens zu ermitteln und festzustellen. Sie berechnet sich nach dem Ver-

kehrswert  des  Anteils  des  ausscheidenden  Gesellschafters  am  Gesellschaftsvermögen  nach  Maßgabe  der  folgenden
Grundsätze:

- Auf den Tag des Ausscheidens ist auf Kosten der Objektgesellschaft eine Stichtagsbilanz zu erstellen.
- Fällt der Tag des Ausscheidens auf das Ende des Geschäftsjahres ist auf den von den Gesellschaftern festgestellten

Jahresabschluss abzustellen, soweit sich aus den nachfolgenden Regelungen nichts Abweichendes ergibt.

- Fällt der Tag des Ausscheidens nicht mit einem Bilanzstichtag zusammen, so sind für die Stichtagsbilanz die Werte

des von den Gesellschaftern auf den letzten Bilanzstichtag vor dem Übertragungsstichtag festgestellten Jahresabschlusses
zugrunde zu legen; diese Werte sind auf den Übertragungsstichtag fortzuschreiben. Die ab dem Tag des Ausscheidens
geleisteten Einlagen sind hinzuzurechnen, die Entnahmen abzusetzen.

- Für Zwecke der Berechnung der Abfindung sind sämtliche Guthaben auf Sonderrücklagenkonten fiktiv wie Verbind-

lichkeiten der Gesellschaft zu behandeln und vermögensmindernd anzusetzen.

- Anstelle des Buchwerts der von der Gesellschaft gehaltenen Immobilien sind diese mit ihrem Verkehrswert anzu-

setzen.

c) Das gemäß Stichtagsbilanz ermittelte Eigenkapital multipliziert mit dem prozentualen Anteil des ausscheidenden

Gesellschafters am gesamten Gesellschaftskapital (maßgeblich ist allein das Verhältnis der Kapitalkonten ohne Berück-
sichtigung von Sonderrücklagenkonto und Darlehenskonto) ergibt den Anteil des ausscheidenden Gesellschafters am
Gesellschaftsvermögen. Dieser Betrag zuzüglich dem dem Gesellschaftsanteil des ausscheidenden Gesellschafters zuzu-
rechnenden Guthaben auf dem Sonderrücklagenkonto entspricht dem Abfindungsguthaben.

d) Wird der Gesellschafter gemäß § 13 aus der Gesellschaft ausgeschlossen, so steht dem betroffenen Gesellschafter

nur eine Abfindung zum Buchwert seiner Beteiligung zu. Dieser bemisst sich nach dem Guthaben auf dem für ihn geführten
Kapitalkonto zuzüglich dem dem Gesellschaftsanteil des ausscheidenden Gesellschafters zuzurechnenden Guthaben auf
dem Sonderrücklagenkonto.

e) Die Abfindung ist sofort zur Zahlung fällig und ohne Anfall von Zinsen innerhalb einer Frist von vier (4) Monaten

nach dem Ausscheiden des Gesellschafters zahlbar.

f) Mit der Abfindung ist auch der Anteil des ausscheidenden Gesellschafters am laufenden Ergebnis des Geschäftsjahres,

in dem der Gesellschafter unterjährig ausscheidet, abgegolten. Der ausscheidende Gesellschafter nimmt am Gewinn und
Verlust aus den am Ausscheidenszeitpunkt schwebenden Geschäften nicht teil.

(2) Der ausgeschiedene Gesellschafter kann keine Sicherheitsleistung verlangen.
(3) Ein Guthaben auf dem Darlehenskonto ist dem Gesellschafter unverzüglich nach seinem Ausscheiden auszuzahlen,

ein Schuldsaldo unverzüglich von ihm auszugleichen.

147022

L

U X E M B O U R G

(4) Nachträgliche Änderungen der Jahresabschlüsse infolge steuerlicher Außenprüfungen oder aus anderen Gründen

bleiben auf die Abfindung ohne Einfluss.

(5) Einigen sich die Beteiligten nicht über das zu ermittelnde Abfindungsguthaben, entscheidet über die strittigen Punkte

ein Wirtschaftsprüfer als Schiedsgutachter verbindlich für die Beteiligten. Der Schiedsgutachter ist, sofern sich die Ge-
sellschafter nicht innerhalb von einer Woche nach Aufforderung durch eine Partei verständigt, auf Antrag einer Partei
durch das Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW), Düsseldorf zu benennen. Der Schiedsgutachter entscheidet auch über
die Kosten seiner Inanspruchnahme, wobei Grundlage hierfür das Verhältnis des Obsiegens der Parteien sein soll.

§ 15. Liquidation.

(1) Nach Auflösung der Gesellschaft wird diese abgewickelt. Abwickler (Liquidator) ist der zum Zeitpunkt der Auflö-

sung bestellte Geschäftsführer.

(2) Ein nach vollständiger Abwicklung verbleibender Überschuss steht den Gesellschaftern im Verhältnis ihres Anteils

am Gesellschaftskapital zu.

§ 16. Schlussbestimmungen.

(1) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrages ganz oder teilweise unwirksam oder unanwendbar

sein oder werden, oder sollte sich in diesem Gesellschaftsvertrag eine Lücke befinden, so wird hierdurch die Gültigkeit
der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der unwirksam oder unanwendbaren Bestimmung oder zur Ausfüllung
der Lücke tritt eine angemessene Regelung, die, soweit rechtlich möglich, dem am nächsten kommt, was die Gesellschafter
gewollt haben oder nach dem Sinn und Zweck dieses Gesellschaftsvertrages gewollt haben würden, wenn sie den Punkt
bedacht hätten. Dies gilt auch für die nach § 14 geschuldete Abfindung.

(2) Änderungen oder Ergänzungen sowie die Aufhebung dieses Gesellschaftsvertrages bedürfen der Schriftform.

(3) Jeder Gesellschafter kann in Angelegenheiten der Gesellschaft Auskunft verlangen und Bücher und Schriften der

Gesellschaft in den Geschäftsräumen der Gesellschaft einsehen. Der Prüfungszweck bestimmt Inhalt und Umfang des
Einsichtsrechts. Die Mitgesellschafter sind von einer Kenntnisnahme ihrer personenbezogenen Daten durch den Einsicht
nehmenden Gesellschafter zu schützen (Datenschutz).

(4) Die Gesellschafter können das Information- und Kontrollrecht selbst ausüben oder durch einen von Berufswegen

zur Verschwiegenheit verpflichteten Sachverständigen (Rechtsanwalt, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer) auf eigene Kos-
ten ausüben lassen.

(5) Alle Gesellschafter haben über vertrauliche Angaben und Betriebsgeheimnisse der Gesellschaft Dritten gegenüber

Stillschweigen zu bewahren.

(6) Die Gesellschafter unterliegen aus diesem Gesellschaftsvertrag keinem Wettbewerbsverbot.

(7) Dieser Gesellschaftsvertrag unterliegt dem Gesetz des Großherzogtums Luxemburg.

<i>Kosten und Ausgaben

Jegliche Ausgaben, Kosten, Vergütungen oder ähnliche Abgaben, die aufgrund dieser notariellen Urkunde von der

Gesellschaft getragen werden sollen, werden auf ungefähr EUR 1.750 geschätzt.

Worüber diese notarielle Urkunde in Luxemburg aufgenommen wurde, An dem zu Beginn aufgeführten Tag.

Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache versteht und spricht, stellt hiermit fest, dass die vorliegende

Urkunde auf Verlangen der Erschienenen in englischer Sprache abgefasst wurde gefolgt von einer deutschen Übersetzung.
Auf Ersuchen derselben erschienenen Partei, soll im Falle von Divergenzen die englische Version Vorrang haben.

Nachdem das Dokument dem/den Bevollmächtigten der Erschienenen vorgelesen wurde, der dem Notar mit Nach-

namen,  Vornamen,  Personenstand  und  Wohnsitz  bekannt  ist,  hat/haben  diese/r  Bevollmächtigte/n  der  Erschienenen
gemeinsam mit Uns, dem Notar die vorliegende Urkunde unterzeichnet.

Signé: M. Kdyem, F. Stahlberg, J. Stern et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 01 septembre 2014. LAC/2014/40590 Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-

<i>Le Receveur ff. (signée): Carole FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 septembre 2014.

Référence de publication: 2014142031/860.

(140161513) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2014.

147023

L

U X E M B O U R G

T. Rowe Price (Luxembourg) Management Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 2.400.000,00.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6C, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 33.422.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 septembre 2014.

Référence de publication: 2014143108/10.
(140162082) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2014.

LFC Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Paris Luxembourg Participations S.à r.l.).

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 108.203.

L’an deux mille quatorze, le dix septembre
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

Monsieur Emmanuel LIMIDO, né le 5 janvier 1959 à Paris (France), Directeur de sociétés, demeurant à Dubai (UAE),

Shangri-La résidence 5018, Sheikh Zayed Road,

ici représenté par Monsieur Geoffrey HUPKENS, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une pro-

curation sous seing privée lui délivrée.

Laquelle procuration après avoir été signée “ne varietur” par le mandataire du comparant et par le notaire instru-

mentant demeurera annexée au présent acte pour être soumise ensemble aux formalités de l’enregistrement.

Le comparant dûment représenté agissant en tant qu'associé unique de la société à responsabilité limitée "PARIS

LUXEMBOURG PARTICIPATIONS S.à r.l.", ayant son siège social à L-2661 Luxembourg, 42, Rue de la Vallée, constituée
suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem en date du 24 mai 2005, publié au Mémorial
C numéro 990 du 05 octobre 2005, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro
B 108.203.

Ensuite le comparant dûment représenté, représentant l’intégralité du capital social a pris la résolution suivante:

<i>Première résolution

L'associé unique décide de changer la dénomination de la société de "PARIS LUXEMBOURG PARTICIPATIONS S.à

r.l." en "LFC Invest S.à r.l.".

<i>Deuxième résolution

L'associé unique décide, en conséquence de ce qui précède, de modifier l’article 4 des statuts, qui aura désormais la

teneur suivante:

'Art. 4. La société prend la dénomination de LFC Invest S.à r.l."

<i>Frais

Les frais, dépenses, charges et rémunérations en relation avec les présentes sont tous à charge de la société.
Plus rien d'autre ne se trouvant à l’ordre du jour, la comparante dûment représentée a déclaré close la présente

assemblée.

DONT ACTE, passé à Luxembourg en l’étude du notaire instrumentaire, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: HUPKENS, MOUTRIER.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 11/09/2014. Relation: EAC/2014/12154. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): HALSDORF.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 12/09/2014.

Référence de publication: 2014142992/42.
(140162458) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2014.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

147024


Document Outline

Audit &amp; Maintenance S.à r.l.

Bayerische Architektenversorgung &amp; Co. S.N.C.

Black &amp; Decker International Finance 3 Limited

CCP III DK Germany S.à r.l.

Gsmp VI Offshore International Holdings S.à r.l.

Holly Tree Immobilier S.A.

Holly Tree Investments S.A.

International Bénin Group Corporation Luxembourg S.A.

LFC Invest S.à r.l.

Paris Luxembourg Participations S.à r.l.

Sablon International S.A.

Salon Christiane S.àr.l.

Saona S.A.

SEB 10 - SICAV - FIS

SEB 10 - SICAV - FIS

Segepa S.A. SPF

SES

SHCO 17 S.à r.l.

Ships &amp; Ferries International S.A.

Siland Invest S.à r.l.

Simpat S.à r.l.

Société Anonyme pour la Recherche d'Investissements S.A.P.R.I. S.A. société de gestion de patrimoine familial

Société Anonyme pour la Recherche d'Investissements S.A.P.R.I. S.A. société de gestion de patrimoine familial

Société Immobilière DM S.àr.l.

Solfin International S.A.

Sparinvest Holdings SE

Sparinvest Holdings SE

Spinnaker HoldCo S.à r.l.

Squirrel AcquiCo I S.à r.l.

Stadsfeestzaal Lux S.à r.l.

Stena Carron Lux 2 S.à r.l.

Stena Drillmax Lux 2 S.à r.l.

Sungem Serfinco S.à r.l.

Systexan S.à r.l.

Tarmac Investments (China)

Tasco International S.à r.l.

TDL Financing Luxembourg Sàrl

Tedev

Tele Columbus Management S.à r.l.

Terryglas S.à r.l.

Thibauting S.A.

Threestones Capital Management S.A.

Toole S.à r.l.

Trans IV (Luxembourg) Properties S.à r.l.

TRG SOF Holdings IV S.à r.l.

Triton Masterluxco 3 S.à r.l.

Triton Masterluxco 4 S.à r.l.

T. Rowe Price (Luxembourg) Management Sàrl

Turf Développement

UK Logistics Topco I S.à r.l.

Vesuvia S.A.

Victus Holdings (Europe) S.à r.l.

Windfall Lux S.A. SICAV-SIF