This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2970
16 octobre 2014
SOMMAIRE
Abrego Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142524
Actisat S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142515
Actistore S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142517
Actistore S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142514
Aforcomlux SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142516
Amber Properties S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
142519
Arista SA SICAV-SIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142524
Bejimac S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142524
Bewa-Invest Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142518
Bourdon Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
142518
b-to-v Partners S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142520
Cap Decision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142521
Cap Vinci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142521
CD Private Equity Sicar S.à r.l. . . . . . . . . . .
142521
Centuria Capital Développement Durable
S. à r.l. (C2D2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142522
CIPEF VI QGOG S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
142518
ColEssen S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142535
COMMUNICATION, SALES AND MAR-
KETING CONSULT (CSM Consult) S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142514
Compagnie Européenne de Promotion
(C.E.P.) S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142521
Crêperie Bretonne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142518
CSC Computer Sciences Holdings S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142514
CTS Soparfi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142522
Culligan Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
142520
Darena Invest S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142522
Ecosse Acquico S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142559
Geoenergy S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142523
Gestion d'Assurances S.A. . . . . . . . . . . . . . .
142523
Hamilton Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
142547
Hamilton Holding S.C.Sp . . . . . . . . . . . . . . .
142547
Havel Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142523
Home & Garden S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142522
Imso Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142523
Jerona SPF S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142547
JPF Distribution S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
142525
Karl 3 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142559
Lefèvre-Evrard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142514
Liro S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142547
Lockdale Sports s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142514
Mafic S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142515
Neroli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142515
Nextech IV GP S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142527
NSS New Luxco S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142542
Olivia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142519
Omicron Asset Management S.à r.l. . . . . .
142515
Onyxs Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142520
Pearl Management S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
142515
Promanté S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142520
Pro-Toitures Gestion S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
142519
Pro-Toitures S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142519
PS1 Luxco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142536
Starry Dance Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142546
Triton Luxembourg GP Compo S.C.A. . .
142516
Tuilia Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142517
Valentin Capital Management S.A. . . . . . .
142519
Veramont Immeubles S.A. . . . . . . . . . . . . . .
142516
Victoria Capital Holdings S.A. . . . . . . . . . . .
142517
YGIP-ASIA PAC S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
142524
YG IP S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142516
YG S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142516
Zabar Group Holding Sàrl . . . . . . . . . . . . . .
142517
Zephyros Property S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
142518
Zeus Group Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
142517
142513
L
U X E M B O U R G
Lefèvre-Evrard, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 5, rue de l'Industrie.
R.C.S. Luxembourg B 28.283.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014135631/10.
(140154315) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2014.
Lockdale Sports s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4740 Pétange, 5, rue Prince Jean.
R.C.S. Luxembourg B 133.745.
Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014135637/10.
(140154239) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2014.
COMMUNICATION, SALES AND MARKETING CONSULT (CSM Consult) S.à r.l., Société à responsa-
bilité limitée.
Siège social: L-9647 Doncols, 14, Chemin des Douaniers.
R.C.S. Luxembourg B 128.825.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014136044/11.
(140154559) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2014.
CSC Computer Sciences Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 7, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 149.715.
Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de rési-
dence à Esch/Alzette, en date du 6 mars 2014 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 7 avril 2014.
Référence de publication: 2014136052/11.
(140154532) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2014.
Actistore S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 24, avenue du X septembre.
R.C.S. Luxembourg B 72.576.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juillet 2011.
Signature
<i>Le Mandatairei>
Référence de publication: 2014136531/12.
(140155785) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2014.
142514
L
U X E M B O U R G
Mafic S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 171.047.
Le bilan et annexes pour la période du 21 août 2012 au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014135655/10.
(140154398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2014.
Neroli, Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 54.700.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUO
Référence de publication: 2014135682/10.
(140153782) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2014.
Omicron Asset Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 174.746.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil de gérance de la société Omicron Asset Management S.à r.l. tenu au siège sociali>
<i>le 17 juin 2014i>
Le Conseil de Gérance prend note de la démission de M. Lorenzo Raffaghello de sa fonction de Gérant de la société
Omicron Asset Management S.à r.l. à partir de la date du 6 avril 2014.
Référence de publication: 2014135696/11.
(140154488) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2014.
Pearl Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 165.915.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
PEARL MANAGEMENT S.A.
Société Anonyme
Référence de publication: 2014135720/11.
(140153869) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2014.
Actisat S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 24, avenue du X septembre.
R.C.S. Luxembourg B 88.428.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juillet 2011.
Signature
<i>Le Mandatairei>
Référence de publication: 2014136527/12.
(140155397) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2014.
142515
L
U X E M B O U R G
YG IP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.
R.C.S. Luxembourg B 158.763.
Le Bilan au 30 septembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014136430/10.
(140154759) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2014.
YG S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.
R.C.S. Luxembourg B 157.986.
Le Bilan au 30 septembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014136431/10.
(140154805) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2014.
Veramont Immeubles S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 141.866.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
Un administrateuri>
Référence de publication: 2014136415/11.
(140154753) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2014.
Triton Luxembourg GP Compo S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Capital social: EUR 37.510,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 171.140.
Les comptes annuels au 30 septembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Triton Luxembourg GP Compo S.C.A
Un Mandatairei>
Référence de publication: 2014136404/11.
(140154827) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2014.
Aforcomlux SA, Société Anonyme.
Siège social: L-5752 Frisange, 8C, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 154.607.
Monsieur Jean GREFF demeurant à 141, rue nationale F- 57 600 Forbach, fait savoir qu'il démissionne de son mandat
de commissaire aux comptes de la société AFORCOMLUX SA, RC Luxembourg n° B 154 607, dont le siège social est
au 8 C Rue de Luxembourg L-5752 FRISANGE, avec effet au 01/01/2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dudelange, le 01/09/2014.
Jean GREFF.
Référence de publication: 2014136533/12.
(140155729) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2014.
142516
L
U X E M B O U R G
Zeus Group Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 12.560,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 152.931.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 août 2014.
Référence de publication: 2014136438/10.
(140154623) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2014.
Zabar Group Holding Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 110.753.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014136439/10.
(140154767) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2014.
Tuilia Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 130.881.
Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de rési-
dence à Esch/Alzette, en date du 6 mars 2014 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 7 avril 2014.
Référence de publication: 2014136407/11.
(140154845) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2014.
Victoria Capital Holdings S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 91.000,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 129.138.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 août 2014.
Victoria Capital Holdings S.A.
Référence de publication: 2014136416/11.
(140155093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2014.
Actistore S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 24, avenue du X septembre.
R.C.S. Luxembourg B 72.576.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
septembre 2014.
Signature
<i>Le Mandatairei>
Référence de publication: 2014136528/12.
(140155782) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2014.
142517
L
U X E M B O U R G
Zephyros Property S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 161.992.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 29 août 2014.
Référence de publication: 2014136441/10.
(140154925) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2014.
Bourdon Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 180.569.
Les comptes au 31 mars 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Bourdon Holdings S.A.i>
Référence de publication: 2014136550/10.
(140155665) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2014.
Crêperie Bretonne, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8380 Kleinbettingen, 6, rue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 172.410.
Les comptes annuels au 30.06.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
ASSELBORN Philippe
<i>Géranti>
Référence de publication: 2014136592/11.
(140155627) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2014.
CIPEF VI QGOG S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 179.273.
Les comptes annuels pour la période du 4 juillet 2013 (date de constitution) au 31 décembre 2013 ont été déposés
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 août 2014.
Référence de publication: 2014136603/11.
(140155798) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2014.
Bewa-Invest Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 82.021.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire du 21 mars 2013i>
La société BEWECO EMB INVEST S.A., vend 385 parts sociales de la société «BEWA INVEST S.à R.L.» à FARO S.A.,
ayant son siège social au 6 Rue Jos Seyler L-8522 Beckerich, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 96.679
Mamer, le 21 mars 2013.
Référence de publication: 2014136561/12.
(140155757) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2014.
142518
L
U X E M B O U R G
Valentin Capital Management S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.
R.C.S. Luxembourg B 75.100.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014136921/9.
(140155824) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2014.
Pro-Toitures Gestion S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4917 Bascharage, 45, rue de la Continentale.
R.C.S. Luxembourg B 169.652.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014136840/10.
(140155438) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2014.
Pro-Toitures S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4917 Bascharage, 45, rue de la Continentale.
R.C.S. Luxembourg B 63.378.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014136841/10.
(140155440) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2014.
Olivia S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R.C.S. Luxembourg B 86.209.
Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Référence de publication: 2014136820/10.
(140155329) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2014.
Amber Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 4-6, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 129.199.
<i>Extrait des décisions prises lors de la réunion du conseil de gérance tenue le 14 août 2014i>
Le Conseil de Gérance a décidé de transférer le siège social de la société du 7, Avenue Gaston Diderich, L-1420
Luxembourg au 4-6 Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, avec effet au 1
er
Septembre 2014.
Luxembourg, le 14 août 2014.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Géranti>
Référence de publication: 2014136957/15.
(140156086) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2014.
142519
L
U X E M B O U R G
Promanté S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 53/A17, Gruuss-strooss.
R.C.S. Luxembourg B 139.678.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014136832/9.
(140155859) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2014.
Onyxs Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2432 Luxembourg, 1, place de Roedgen.
R.C.S. Luxembourg B 115.048.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014136821/10.
(140155439) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2014.
b-to-v Partners S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 157.948.
<i>Auszug aus dem Gesellschafterbeschluss der b-to-v Partners S.à r.l.i>
der am 08. August 2014 gefasst wurde:
Die Gesellschafter beschließen, Herrn Alexander Stoeckel, geboren am 17.12.1974 in Berlin, Deutschland, wohnhaft
in der Oberstrasse 255, 9014 St. Gallen, Schweiz, mit Wirkung vom 08. August 2014 als neuen Geschäftsführer der b-
to-v Partners S.à r.l. auf unbestimmte Dauer zu ernennen.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 02. September 2014.
<i>Für b-to-v Partners S.à r.l.
i>Die Domizilstelle:
Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services S.A.
Référence de publication: 2014136944/17.
(140155887) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2014.
Culligan Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 15.025,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 101.990.
EXTRAIT
En date du 22 août 2014, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- La démission de M. Robert Gold en tant que gérant de la Société est acceptée avec effet au 11 juillet 2014;
- M. Glen Ferguson, né le 13 février 1964 à Connecticut, États-Unis d'Amérique, avec adresse professionnelle au 9399
West Higgins Road, 60018 Rosemont (Illinois), États-Unis d'Amérique, est nommé nouveau gérant de la Société avec
effet au 11 juillet 2014 et ce pour une durée indéterminée.
Par ailleurs, il convient également de noter que l'adresse de l'associé unique se situe désormais au 15, rue Edward
Steichen, L-2540 Luxembourg.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 1
er
septembre 2014.
Référence de publication: 2014137062/18.
(140155889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2014.
142520
L
U X E M B O U R G
Cap Decision, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2537 Luxembourg, 19, rue Sigismond.
R.C.S. Luxembourg B 175.897.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014137066/9.
(140155908) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2014.
Cap Vinci, Société Anonyme.
Siège social: L-8308 Capellen, 89E, Parc d'Activités.
R.C.S. Luxembourg B 107.519.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014137067/9.
(140156313) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2014.
CD Private Equity Sicar S.à r.l., Société à responsabilité limitée sous la forme d'une Société d'Investisse-
ment en Capital à Risque.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 144.802.
Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014137077/10.
(140156500) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2014.
Compagnie Européenne de Promotion (C.E.P.) S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Pa-
trimoine Familial.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 26.440.
<i>Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 13 juin 2014i>
<i>Deuxième résolutioni>
Les mandats des Administrateurs étant arrivés à échéance à l'issue de la présente Assemblée, l'Assemblée Générale
décide renouveler avec effet immédiat le mandat d'Administrateur et de Président du Conseil d'Administration de M.
Paul JEANBART, né le 23 août 1939 à Alep (Syrie), résidant 1, Rue Pierre Helou, Immeuble Pdt Mouawad, 0000 Hazmieh
(Liban), le mandat d'Administrateur de Monsieur Nicolas HOMSY, Administrateur de Sociétés, né le 10 mars 1942 à Alep
(Syrie), demeurant professionnellement 104, Lancaster Gate, W2 3NT Londres (Grande Bretagne), le mandat d'Admi-
nistrateur de Mme Christina JEANBART, Administrateur, née le 12 décembre 1979 à Jeddah (Arabie Saoudite) résidant
au 25 Quai des Bergues CH-1201 Genève, Suisse pour une nouvelle période de six ans jusqu'à l'issue de l'Assemblée
Générale statutaire annuelle qui se tiendra en 2020.
Le mandat du Commissaire étant arrivé à échéance à l'issue de la présente Assemblée, l'Assemblée Générale décide
de renouveler avec effet immédiat le mandat de Commissaire de la société AUDIEX S.A., ayant son siège social au 9, Rue
du Laboratoire, L-1911 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la
section B et le numéro 65.469, pour une nouvelle période d'un an jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire
annuelle qui se tiendra en 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
COMPAGNIE EUROPEENNE DE PROMOTION (C.E.P.) S.A., SPF
Société anonyme - société de gestion de patrimoine familial
Référence de publication: 2014137087/26.
(140156136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2014.
142521
L
U X E M B O U R G
CTS Soparfi S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8080 Bertrange, 2, rue Pletzer.
R.C.S. Luxembourg B 155.837.
Le Bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Signature.
Référence de publication: 2014137094/10.
(140156476) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2014.
Centuria Capital Développement Durable S. à r.l. (C2D2), Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.
R.C.S. Luxembourg B 130.606.
Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014137081/10.
(140156024) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2014.
Home & Garden S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5427 Greiveldange, 4A, Bechelsbierg.
R.C.S. Luxembourg B 164.114.
Par la présente, je tiens à vous informer que je renonce avec effet immédiat à mon mandai comme commissaire aux
comptes de:
Home & Garden S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5427 Greiveldange, 4A, Bechelsbierg.
R.C.S. Luxembourg B 164.114.
Greiveldange, le 30 août 2014.
Ruffini Nicolas.
Référence de publication: 2014137219/13.
(140155926) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2014.
Darena Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 156.734.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 28 août 2014i>
L'associé unique de la Société:
- approuve le rapport du commissaire à la liquidation de la Société;
- donne décharge au commissaire à la liquidation, au liquidateur et aux gérants de la Société;
- prononce la clôture de la liquidation et constate que la Société a définitivement cessé d'exister en date du 28 août
2014;
- décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq (5) ans à l'adresse
suivante: 9A, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
septembre 2014.
Darena Invest S.à r.l., en liquidation volontaire
Signature
Référence de publication: 2014137096/21.
(140156219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2014.
142522
L
U X E M B O U R G
Geoenergy S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 64.589.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUO
Référence de publication: 2014136152/10.
(140154964) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2014.
Gestion d'Assurances S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8832 Rombach, 18, route de Bigonville.
R.C.S. Luxembourg B 123.602.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014136155/10.
(140154564) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2014.
Havel Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 870.000,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 112.533.
Veuillez noter que l'adresse des associés de la Société a changé comme tel:
- Piccadilly Major Capital S.à r.l.: 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg;
- Piccadilly Minor Capital S.à r.l.: 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 02 septembre 2014.
<i>Pour la Sociétéi>
Référence de publication: 2014137207/14.
(140156586) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2014.
Imso Lux S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 45, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 173.565.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 2 septembre 2014i>
Après délibération l'assemblée prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Résolutions:i>
1. La démission de la société REVICONSULT S.à r.l. de son mandat de Commissaire aux Comptes est acceptée;
2. la société Magister Audit Services S.à R.L., Société à Responsabilité Limitée, 45 Avenue de la Liberté, L - 1931
Luxembourg, RCS B 183.813, est nommée en tant que nouveau Commissaire aux Comptes, en remplacement du Com-
missaire aux Comptes démissionnaire, pour une période statutaire de 6 ans, soit jusqu'à l'assemblée générale statutaire
appelée à délibérer sur les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2019.
3. Monsieur Stéphane Allart, administrateur unique de la société, a changé d'adresse professionnelle, qui est désormais
située au 45, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Luxembourg.
Référence de publication: 2014137235/20.
(140156564) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2014.
142523
L
U X E M B O U R G
Bejimac S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9952 Drinklange, Maison 17.
R.C.S. Luxembourg B 96.241.
Le Bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
septembre 2014.
CHOTIN Barbara.
Référence de publication: 2014136556/10.
(140155848) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2014.
YGIP-ASIA PAC S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.
R.C.S. Luxembourg B 158.765.
Le Bilan au 30 septembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014136432/10.
(140154809) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2014.
Abrego Lux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 79.584.
Le bilan au 31/12/2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 septembre 2014.
Référence de publication: 2014136972/10.
(140156479) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2014.
Arista SA SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 132.056.
Lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 30 avril 2014, les actionnaires ont pris les décisions suivantes:
1. Renouvellement du mandat des administrateurs suivants:
- Alain Heinz, administrateur de catégorie B, avec adresse professionnelle au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511
Luxembourg
- Mette Skov, administrateur de catégorie A, avec adresse au 6, Kampmannsgade, 1604 Copenhague V, Danemark
- Frantz Palludan, administrateur de Classe A, avec adresse au 16, Frederiksberggade, 1459 Copenhague, Danemark
- Nikolaj Stampe, administrateur de catégorie A, avec adresse au 3, Tuborg Boulevard, 2900 Hellerup, Danemark
- Peer Munkholt, administrateur de catégorie A, avec adresse au 4, Bremerholm, 1069 Copenhague K, Danemark
pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice
social se clôturant au 31 décembre 2014 et qui se tiendra en 2015;
2. Acceptation de la démission de Peter Mollerup, avec adresse au 31-33, Kalvebod Brygge, 1780 Copenhague V,
Danemark, de son mandat d' administrateur de catégorie A avec effet au 11 novembre 2013.
3. Renouvellement du mandat de réviseur d'entreprises agréé de PricewaterhouseCoopers, avec siège social au 400,
route d'Esch, L-1741 Luxembourg, pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera
sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2014 et qui se tiendra en 2015;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 août 2014.
Référence de publication: 2014136995/24.
(140155879) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2014.
142524
L
U X E M B O U R G
JPF Distribution S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5670 Altwies, 1, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 189.784.
STATUTS
L'an deux mille quatorze, le dix-huit août.
Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.
ONT COMPARU:
1.- Monsieur Patrick HOFFMANN, directeur technique, né à Metz (France) le 20 janvier 1966, demeurant à F-57365
Flévy, 37, Grand-Rue.
2.- Monsieur Joël CLAUDE, chef d’entreprise, né à Bar-le-Duc (France) le 17 septembre 1958, demeurant à F-88400
Gérardmer, 4, rue de la République.
3.- Monsieur Franck ESCLARMONDE, chef d’entreprise, né à Hèches (France) le 30 août 1963, demeurant à F-65410
Sarrancolin, 69, route d’Espagne.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils vont constituer
entre eux.
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de "JPF DISTRIBUTION s.à r.l.".
Art. 2. Le siège de la société est établi à Altwies; il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de
Luxembourg en vertu d'une décision de l’assemblée générale extraordinaire des associés.
La société pourra établir des filiales et des succursales aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l’étranger.
Art. 3. La société a pour objet le commerce de véhicules motorisés ainsi que d’accessoires et de pièces détachées y
relatifs.
La société est autorisée à contracter des emprunts pour son propre compte et à accorder tous cautionnements ou
garanties.
La société pourra effectuer toutes activités et opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières, immo-
bilières ou autres se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles d'en favoriser la
réalisation.
Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (€ 12.500.-), représenté par cent (100) parts sociales
d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (€ 125.-) chacune.
Art. 6. Les parts sociales ne sont cessibles entre vifs à des tiers non-associés qu'avec le consentement préalable des
associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément
préalable des propriétaires de parts sociales représentant au moins les trois-quarts des droits appartenant aux survivants.
En cas de cession, la valeur d'une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la société.
Art. 7. La cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé.
Elle n'est opposable à la société et aux tiers qu'après avoir été notifiée à la société ou acceptée par elle conformément
à l’article 1690 du Code Civil.
Art. 8. En cas de décès d'un associé, gérant ou non gérant, la société ne sera pas dissoute et elle continuera entre les
associés survivants et les héritiers de l’associé décédé.
L'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un quelconque des associés ne met pas fin à la société.
Art. 9. Chaque part est indivisible à l’égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter
auprès de la société par un seul d'entre eux ou un mandataire commun choisi parmi les associés.
Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu'elle passe. La propriété d'une part
emporte de plein droit adhésion aux présents statuts.
Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, requérir l’apposition de scellés
sur les biens et documents de la société ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; ils doivent,
pour l’exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par l’assemblée des associés à la majorité du
capital social et pris parmi les associés ou en dehors d'eux.
L'acte de nomination fixera la durée de leurs fonctions et leurs pouvoirs.
142525
L
U X E M B O U R G
Les associés pourront à tout moment décider de la même majorité la révocation du ou des gérants pour causes
légitimes, ou encore pour toutes raisons quelles qu'elles soient, laissées à l’appréciation souveraine des associés moyen-
nant observation toutefois, en dehors de la révocation pour causes légitimes, du délai de préavis fixé par le contrat
d'engagement ou d'un délai de préavis de deux mois.
Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et
pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Le ou les gérants ont la signature sociale et ils ont
le droit d'ester en justice au nom de la société tant en demandant qu'en défendant.
Art. 11. Le décès du ou des gérants ou leur retrait, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la
société.
Les héritiers ou ayants-cause du ou des gérants ne peuvent en aucun cas faire apposer des scellés sur les documents
et registres de la société, ni faire procéder à un inventaire judiciaire des valeurs sociales.
Art. 12. Les décisions des associés sont prises en assemblée générale ou encore par un vote écrit sur le texte des
résolutions à prendre et qui sera communiqué par lettre recommandée par la gérance aux associés.
Le vote écrit devra dans ce dernier cas être émis et envoyé à la société par les associés dans les quinze jours de la
réception du texte de la résolution proposée.
Art. 13. A moins de dispositions contraires prévues par les présents statuts ou par la loi, aucune décision n'est vala-
blement prise que pour autant qu'elle ait été adoptée par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si
ce quorum n'est pas atteint à la première réunion ou lors de la consultation par écrit, les associés sont convoqués ou
consultés une seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que
soit la portion du capital représenté.
Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu’à la majorité des
associés représentant les trois quarts du capital social.
Art. 14. Les décisions sont constatées dans un registre de délibérations tenu par la gérance au siège social et auquel
seront annexées les pièces constatant les votes exprimés par écrit ainsi que les procurations.
Art. 15. L'exercice social commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 16. Il sera dressé à la fin de l’exercice social un inventaire général de l’actif et du passif de la société et un bilan
résumant cet inventaire. Chaque associé ou son mandataire muni d'une procuration écrite pourront prendre au siège
social communication desdits inventaire et bilan.
Art. 17. Les produits de la société, constatés par l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, des charges
sociales, de tous amortissements de l’actif social et de tous comptes de provisions pour risques commerciaux ou autres,
constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution du fonds de réserve
légale jusqu'à ce qu'il ait atteint le dixième du capital social.
Le solde du bénéfice sera à la disposition des associés qui décideront de son affectation ou de sa répartition.
S'il y a des pertes, elles seront supportées par tous les associés dans les proportions et jusqu'à concurrence de leurs
parts sociales.
Art. 18. En cas de dissolution anticipée, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés
par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 19. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées conformément à la loi du
18 septembre 1933 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.
<i>Souscription et libérationi>
Les parts sociales ont été souscrites comme suit:
1) Monsieur Patrick HOFFMANN, préqualifié,
vingt-quatre parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
2) Monsieur Joël CLAUDE, préqualifié,
trente-huit parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38
3) Monsieur Franck ESCLARMONDE, préqualifié,
trente-huit parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille
cinq cents euros (€ 12.500.-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au
notaire instrumentant, qui le constate expressément.
<i>Disposition transitoirei>
Exceptionnellement le premier exercice prend cours le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2014.
142526
L
U X E M B O U R G
<i>Fraisi>
Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui
sont mis à charge à raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à mille euros (€ 1.000.-).
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Ensuite, les comparants représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire
à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils
ont pris à l’unanimité des voix les décisions suivantes:
1) Monsieur Patrick HOFFMANN, préqualifié, est nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée.
2) La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.
3) Le siège social est fixé à L-5670 Altwies, 1, route de Luxembourg.
Les comparants déclarent, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu’elle a été modifiée par la suite, être
les bénéficiaires réels de la société faisant l’objet des présentes et agir pour leur propre compte et certifient que les fonds
servant à la libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livrera pas à des activités
constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels
que définis à l’article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).
Le notaire instrumentant a rendu attentifs les comparants au fait qu’avant toute activité commerciale de la société
présentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.
DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: HOFFMANN, CLAUDE, ESCLARMONDE, A. WEBER.
Enregistré à Capellen, le 25 août 2014. Relation: CAP/2014/3252. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): NEU.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande.
Bascharage, le 27 août 2014.
Référence de publication: 2014135597/133.
(140153727) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2014.
Nextech IV GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 1c, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 189.785.
STATUTES
In the year two thousand fourteen, on the twentieth day of August,
Before the undersigned Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
THERE APPEARED:
1. Nextech Holding AG, a public limited liability company, organized and existing under the laws of Switzerland with
registered office in Hadlaubstrasse 14, 8044 Zurich, Switzerland and registered in the Commercial Register of the Canton
of Zürich under number CH-020.3.034.688-4; and
2. Prof. Dr. David Morse Livingston, residing in 11 Powell Street, Brookline, MA 02446, United States of America; and
3. Prof. Dr. William G. Kaelin, residing in 177 Commonwealth Avenue, Boston, MA 02116, United States of America;
and
4. Prof. Dr. Glenn Dranoff, residing in 150 Concord Road, Sudbury, MA 01776, United States of America; and
5. Dr. Charles L. Sawyers, residing in 40 E 61
st
Street, Apt. 9C, New York, NY 10065, United States of America; and
6. Prof. Dr. Karl-Heinz Altmann, residing in Tannenweg 5, 4153 Reinach, Switzerland; and
7. Prof. Dr. Paul Workman, residing in Pinehurst, Glebe Lane, Abinger Common, Surrey RH5 6JQ, United Kingdom;
and
8. Dr. Thomas Lips, residing in Maseschastrasse 63, 9497 Triesenberg, Liechtenstein; and
9. Dr. Thilo Schroeder, residing in Lothringerstrasse 121, 4056 Basel, Switzerland,
all here represented by Mr. Christoph Junk, with professional address in 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach,
Grand Duchy of Luxembourg by virtue of several proxies.
142527
L
U X E M B O U R G
The said proxies, initialled “ne varietur” by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The appearing parties, duly represented, have required the officiating notary to enact the deed of incorporation of a
private limited liability company (société à responsabilité limitée) which is declared organized and the articles of association
of which shall be as follows:
A. Name - Purpose - Duration - Registered office
Art. 1. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name of Nextech IV
GP S.à r.l. (the “Company”) which shall be governed by the Luxembourg law of 10 August 1915 concerning commercial
companies, as amended (the “1915 Law”), as well as by the present articles of association (the “Articles”).
Art. 2. The purpose of the Company is to acquire and hold a participation in Nextech IV Oncology S.C.S. SICAV-SIF,
a Luxembourg specialized investment fund, incorporated as a Luxembourg limited partnership (société en commandite
simple - S.C.S.) and to act as its general partner and partner with unlimited liability.
The Company may carry out any commercial or financial activities which it may deem useful in the accomplishment
of its purposes.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.
Art. 4. The registered office of the Company is established in the municipality of Schuttrange, Grand Duchy of Lu-
xembourg. The registered office may be transferred within the same municipality by decision of the board of managers.
The registered office of the Company may be transferred to another place within the Grand Duchy of Luxembourg
by a resolution of an extraordinary general meeting passed by a majority of Members representing at least three quarters
of the corporate capital and in accordance with the 1915 Law.
Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of
the board of managers.
In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social developments
have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or
with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company.
B. Corporate capital - Corporate units
Art. 5. The Company's corporate capital is set at USD 20’000 (twenty thousand US Dollars) represented by 20’000
(twenty thousand) corporate units (the “Units”) with a par value of USD 1 (one US Dollar) each.
Each unit is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings of Members.
Art. 6. The corporate capital may be modified at any time by approval of a majority of Members representing at least
three quarters of the corporate capital and in accordance with the 1915 Law.
Art. 7. The Company will recognize only one holder per unit. Joint co-owners shall appoint a joint representative who
shall represent them towards the Company.
Art. 8. The Company's Units are freely transferable among Members. Any inter vivos transfer to non-Members is
subject to the approval given in the general meeting by Members representing at least three quarters of the corporate
capital.
Units may not be transmitted by reason of death to non-Members except with the approval of Members representing
at least three quarters of the rights owned by the survivors, subject to and in accordance with the 1915 Law. No consent
shall however be required where the Units are transferred either to heirs compulsory entitled to a portion of the estate
or to the surviving spouse or to other legal heirs.
No consent shall be required for transfers of Units to non-Members if the Company only has one sole Member.
The Company may have one or several Members, with a maximum number of 40 (forty), unless otherwise provided
for in the 1915 Law.
Art. 9. Subject to compliance to the 1915 Law, the Company is authorized to acquire Units representing its own capital.
C. Management
Art. 10. The Company is managed by at least 3 (three) managers (the “Managers”). The Managers form the board of
managers (the “Board“). The Managers are not required to be members of the Company (the “Members”). The Managers
are appointed by the General Meeting for an undetermined term. The Managers may be revoked at any time ad nutum
by the Members representing at least three quarters of the corporate capital of the Company.
142528
L
U X E M B O U R G
The Board is invested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for the accomplishment of the
corporate purpose of the Company, except those expressly reserved by applicable law or by the present Articles to the
general meeting of Members.
Art. 11. The Company will be bound in all circumstances by the collective signature of any two Managers.
Below the materiality threshold of EUR 500 (five hundred euros) or its equivalent in USD, the sole signature of any
Manager is sufficient.
Any Manager may sub-delegate its powers for specific tasks to one or several authorized representative(s). The relevant
Manager sets out the responsibilities, eventually the remuneration(s) and any other relevant conditions in relation to such
authorized representative(s).
The Board is further authorized to establish rules governing servicing the management of its affairs. For the adoption
or the amendment of such rules, an unanimous decision of the Board is required.
Art. 12. The Board may choose from among its Managers a chairman, and, as the case may be, a vice-chairman. It may
also choose a secretary, who need not be a Manager and who shall be responsible for the minutes of the meetings of the
Board and general meetings. The first Chairman may be designated by the general meeting of shareholders.
The Board shall meet upon call by the chairman, or 2 (two) Managers, at the place indicated in the notice of meeting.
The meetings of the Board shall be held at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice
of meeting. The chairman shall preside at meetings of the Board. In his absence, the Board may appoint another Manager
as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the Board must be given to the Managers at least 24 (twenty four) hours in advance
of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the
emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be waived by consent in writing, by facsimile, e-mail or any
other similar means of communication. A separate notice will not be required for a board meeting to be held at a time
and location determined in a prior resolution adopted by the Board.
No notice shall be required to the extent all the Managers are present or represented at a meeting of the Board or
in the case of written resolutions approved and signed by all the Managers.
Any Manager may arrange to be represented at any meeting of the Board by appointing in writing or by facsimile, e-
mail or any other similar means of communication another manager as his proxy. One individual Manager may represent
several other Managers.
Any Manager may participate in any meeting of the Board by conference-call, videoconference or by other similar
means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another on a continuous basis
and allowing an effective participation of all such persons in the meeting. The participation in a meeting by these means
is equivalent to a participation in person at such meeting. If a resolution is taken by way of conference-call, videoconference
or by similar means of communication, the resolution shall be considered to have been taken in Luxembourg if the call
is initiated from Luxembourg.
The Board can only deliberate or act validly if at least a majority of the Managers is present or represented at a meeting
of the Board. Resolutions of the Board shall be adopted by the majority of votes of the Managers present either in person
or by proxy; in case of tied votes, the chairman shall have a casting vote.
The Board may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by facsimile,
e-mail or any other similar means of communication. The entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.
Art. 13. The minutes of any meeting of the Board shall be signed by the chairman, or by 2 (two) Managers. Copies or
extracts of such minutes which may be submitted at judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman or
by 2 (two) Managers or by any person duly appointed to that effect by the Board.
Art. 14. The death or resignation of a Manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the
Company.
Art. 15. The liability of the Managers shall be determined in accordance with Article 59 of the 1915 Act.
D. General meeting of members
Art. 16. If the Company has several Members, each Member may participate in collective decisions irrespective of the
number of Units such Member owns. Each Member is entitled to as many votes as he holds or represents Units.
If the Company has one sole Member, such Member shall exercise all the powers vested with the general meeting of
the Members as provided for in section XII of the 1915 Law.
Any Member may, by a written proxy, authorize any other person, who need not to be a Member, to represent him
at a general meeting and to vote in his name and stead.
If a Member is a legal entity, it acts in general meetings through its legal representative(s).
Resolutions shall be validly adopted at general meetings by the Members representing at least two-thirds of the cor-
porate capital of the Company. However, resolutions to alter the Articles of the Company or to liquidate the Company
142529
L
U X E M B O U R G
may only be adopted by the Members representing at least three quarters of the corporate capital of the Company,
further subject to the 1915 Law.
The holding of general meetings shall not be obligatory where the number of Members does not exceed 25 (twenty
five) but may be made in writing by all the Members. In such case, each Member shall receive a draft of the resolutions
to be adopted, which is to be signed by it. Such a resolution in writing that has been made in one or more copies instead
of holding a general meeting is considered a decision that has exact the same authority as it would have if passed at a
general meeting.
Any reference in these Articles to resolutions of the general meeting shall be construed as also referring to written
resolutions of the Members, provided the Company having not more than 25 (twenty five) Members.
E. Financial year - Annual accounts - Statutory reserves - Distribution of profits
Art. 17. The Company's financial year commences on the first day of January and ends on the last day December of
the same year.
Each year as per the last day of December an inventory of the assets and liabilities of the Company as well as a balance
sheet and a profit and loss account shall be drawn up.
Each Member may inspect the above mentioned inventory, the balance sheet and the profit and loss account at the
Company’s registered office.
Art. 18. The revenues of the Company, deduction made of the general expenses and the charges, the depreciations,
the provisions and taxes constitute the net profit. 5% (five per cent) of this net profit shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory as soon as the reserve amounts to 10% (ten per cent) of the corporate
capital of the Company, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason
whatsoever, it has been touched.
The remainder of the net profit may be distributed to the Member(s) in relation to the number of Units held by them.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 19. The death, legal incapacity, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any similar event
regarding any of the Members or the sole Member as the case may be will not cause the dissolution of the Company.
Dissolution of the Company may take place at any time pursuant to a decision adopted by the general meeting in accor-
dance with the conditions laid down for amendments to the Articles.
In case of dissolution of the Company the liquidation will be carried out by one or more liquidators who need not be
Members, designated by the general meeting at the majority defined by Article 142 of the 1915 Law. The liquidator(s)
shall be invested with the broadest powers for the realization of the assets and payment of the liabilities.
The surplus after payment of all charges, debts, expenses which are a result of liquidation, will be used to reimburse
the contribution made by the Members on the Units of the Company.
The final surplus will be distributed to the Members in proportion to their respective participation in the Company.
G. Governing law
Art. 20. These Articles shall be construed and interpreted under and shall be governed by Luxembourg law.
All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the 1915 Law.
H. Transitional provision
The first financial year of the Company shall begin on the date of formation and shall end on the last day of December
2014.
I. Subscription and payment
The shares have been subscribed as follows:
Nextech Holding AG, aforementioned . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10’810 Units
Prof. Dr. David Morse Livingston, aforementioned . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2’220 Units
Prof. Dr. William G. Kaelin, aforementioned . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
594 Units
Prof. Dr. Glenn Dranoff, aforementioned . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
594 Units
Dr. Charles L. Sawyers, aforementioned . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
594 Units
Prof. Dr. Karl-Heinz Altmann, aforementioned . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
594 Units
Prof. Dr. Paul Workman, aforementioned . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
594 Units
Dr. Thomas Lips, aforementioned . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 Units
Dr. Thilo Schroeder, aforementioned . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3’500 Units
TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20’000 Units
The Units have been fully paid up to the amount of USD 1 (one US Dollar) per corporate unit by a contribution in
cash of USD 20’000 (twenty thousand US Dollars).
142530
L
U X E M B O U R G
As a result, the amount of USD 20’000 (twenty thousand US Dollars) is as of now at the disposal of the Company as
has been certified to the notary executing this deed.
J. Expenses
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever and which shall be borne by the Company as
a result of its incorporation are estimated at approximately EUR 1,800.-.
K. Extraordinary general meeting
After the Articles have thus been drawn up, the above named Members have immediately proceeded to hold an
extraordinary general meeting. Having first verified that it was regularly constituted, it passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company shall be at 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of
Luxembourg;
2. The following persons are elected Manager of the Company for an undetermined term:
- Dr. Thomas Lips, born in Zurich, Switzerland, on July 3, 1949, with professional address at Scheuchzerstrasse 35,
CH-8006 Zurich, Switzerland; and
- Marc Kriegsmann, born in Lich, Germany, on February 12, 1976, with professional address at 1c, rue Gabriel Lipp-
mann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg; and
- Christoph Kraiker born in Trier, Germany, on July 2, 1980, with professional address at 1c, rue Gabriel Lippmann,
L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg.
Chairman of the Board of Managers is Dr. Thomas Lips.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing person,
the present incorporation deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same
appearing person and in case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.
WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this
document.
The document having been read to the appearing person, known to the notary by name, first name and residence, the
said appearing person signed together with the notary, the present deed, which contains two cancelled blanks.
Follows the german translation of the prededing text
Im Jahr Zweitausendundvierzehn, am zwanzigsten Tag des Monats August,
vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
SIND ERSCHIENEN:
1. Nextech Holding AG, eine nach Schweizer Recht gegründete und bestehende Aktiengesellschaft mit Sitz in Had-
laubstrasse 14, 8044 Zürich, Schweiz, und eingetragen im Handelsregister des Kantons Zürich, Schweiz, unter der
Nummer CH-020.3.034.688-4; und
2. Prof. Dr. David Morse Livingston, wohnhaft in 11 Powell Street, Brookline, MA 02446, USA; und
3. Prof. Dr. William G. Kaelin, wohnhaft in 177 Commonwealth Avenue, Boston, MA 02116, USA; und
4. Prof. Dr. Glenn Dranoff, wohnhaft in 150 Concord Road, Sudbury, MA 01776, USA; und
5. Dr. Charles L. Sawyers, wohnhaft in 40 E 61
st
Street, Apt. 9C, New York, NY 10065, USA; und
6. Prof. Dr. Karl-Heinz Altmann, wohnhaft in Tannenweg 5, 4153 Reinach, Schweiz; und
7. Prof. Dr. Paul Workman, wohnhaft in Pinehurst, Glebe Lane, Abinger Common, Surrey RH5 6JQ, Großbritannien;
und
8. Dr. Thomas Lips, wohnhaft in Maseschastrasse 63, 9497 Triesenberg, Liechtenstein; und
9. Dr. Thilo Schroeder, wohnhaft in Lothringerstrasse 121, 4056 Basel, Schweiz,
alle hier vertreten durch Herrn Christoph Junk, geschäftlich ansässig in 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach,
Großherzogtum Luxemburg, aufgrund mehrerer privatschriftlich ausgestellter Vollmachten.
Die vorerwähnten Vollmachten bleiben, nach Paraphierung ne varietur durch den Vertreter der erschienenen Partei
und den beurkundenden Notar, vorliegender Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben hinterlegt zu werden.
Die erschienene Parteien, vertreten wie oben angegeben, haben den unterzeichneten Notar ersucht, die Gründung
einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung urkundlich festzustellen, wie hiermit beschlossen wird und deren Satzung
wie folgt lautet:
A. Name - Zweck - Dauer - Sitz
Art. 1. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Firmennamen
Nextech IV GP S.à r.l. (nachstehend die “Gesellschaft“) welche den Bestimmungen des Gesetzes über Handelsgesell-
schaften vom 10. August 1915 in seiner jeweils gültigen Fassung (das “Gesetz über Handelsgesellschaften“) und den
Bestimmungen der vorliegenden Satzung unterliegt.
142531
L
U X E M B O U R G
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und das Halten einer Beteiligung in Nextech IV Oncology S.C.S. SICAV-
SIF, ein luxemburgischer spezialisierter Investmentfonds, gegründet in der Rechtsform einer société en commandite simple
(einfache Kommanditgesellschaft), und das Agieren als dessen Komplementär und unbeschränkt haftender Gesellschafter.
Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten gewerblicher oder finanzieller Natur vornehmen, die ihr zur Erreichung ihrer
Zwecke förderlich erscheinen.
Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet.
Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Schuttrange, Großherzogtum Luxemburg. Der Ge-
sellschaftssitz kann durch einen Beschluss des Rates der Geschäftsführer, an jeden beliebigen Ort in derselben Gemeinde
verlegt werden.
Der Sitz der Gesellschaft kann durch einen Beschluss einer außerordentlichen Generalversammlung von einer Mehrheit
der Gesellschafter, welche mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten und in Übereinstimmung mit dem
Gesetz über Handelsgesellschaften, an einen anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.
Die Gesellschaft kann durch einen Beschluss des Rates der Geschäftsführer, Zweigstellen oder Agenturen sowohl in
Luxemburg als auch im Ausland errichten.
Sollte der Rat der Geschäftsführer feststellen, dass außerordentliche politische, wirtschaftliche oder gesellschaftliche
Entwicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Tätigkeiten der Gesellschaft an
ihrem Gesellschaftssitz oder die Kommunikation zwischen ihrem Gesellschaftssitz und Personen im Ausland beeinträch-
tigen können, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur vollständigen Normalisierung der Verhältnisse ins
Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft,
welche trotz einer vorübergehenden Verlegung ihres Gesellschaftssitzes eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.
B. Gesellschaftskapital - Gesellschaftsanteile
Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt USD 20‘000 (zwanzigtausend USDollar), eingeteilt in 20‘000 (zwanzigtausend)
Gesellschaftsanteile (die “Anteile“) zu je USD 1 (ein US-Dollar).
Jeder Gesellschaftsanteil gewährt eine Stimme bei ordentlichen und außerordentlichen Generalversammlungen.
Art. 6. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch Beschluss einer Mehrheit von Gesellschaftern, die mindestens
drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten und in Übereinstimmung mit dem Gesetz über Handelsgesellschaften
geändert werden.
Art. 7. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Inhaber pro Gesellschaftsanteil an. Steht ein Gesellschaftsanteil
mehreren Berechtigten zu, so ernennen sie einen gemeinschaftlichen Vertreter, der sie gegenüber der Gesellschaft ver-
tritt.
Art. 8. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung von Anteilen unter
Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Zustimmung von Gesellschaftern, die mindestens drei Viertel des Gesell-
schaftskapitals vertreten.
Im Fall des Todes eines Gesellschafters können die Anteile des verstorbenen Gesellschafters an Nichtgesellschafter
nur mit Zustimmung der Gesellschafter, die mindestens drei Viertel der Rechte der Überlebenden vertreten und in
Übereinstimmung und unter den Voraussetzungen des Gesetzes über Handelsgesellschaften, übertragen werden. Eine
derartige Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn die Übertragung der Anteile entweder an pflichtteilsberechtigte Erben
oder auf den überlebenden Ehepartner oder auf die anderen gesetzlichen Erben erfolgt.
Falls die Gesellschaft nur einen Gesellschafter hat, sind die Anteile an Nichtgesellschafter frei übertragbar.
Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, jedoch höchstens 40 (vierzig), sofern nichts Gegen-
teiliges gemäß Gesetz über Handelsgesellschaften vorgeschrieben ist.
Art. 9. Die Gesellschaft ist ermächtigt, Anteile an ihrem eigenen Kapital zu erwerben, solange sie dabei die Bestim-
mungen des Gesetzes über Handelsgesellschaften beachtet.
C. Geschäftsführung
Art. 10. Die Geschäftsführung der Gesellschaft obliegt mindestens 3 (drei) Geschäftsführern. Diese bilden den Rat der
Geschäftsführer. Die Geschäftsführer brauchen nicht Gesellschafter zu sein. Die Geschäftsführer werden von der Ge-
neralversammlung auf unbestimmte Zeit ernannt. Die Geschäftsführer können jederzeit und ad nutum von den Gesell-
schaftern, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, abberufen werden.
Der Rat der Geschäftsführer ist mit den größtmöglichen Befugnissen ausgestattet, um alle Handlungen zur Verwaltung
und Geschäftstätigkeit der Gesellschaft im Einklang mit dem Gesellschaftszweck durchführen zu können, wobei ihm alle
Befugnisse zustehen, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder diese Satzung der Gesellschafterversammlung zuge-
schrieben werden.
Art. 11. Die Gesellschaft wird jederzeit durch die gemeinsame Unterschrift zweier Geschäftsführer verpflichtet.
Unterhalb der Bagatellgrenze von EUR 500 (fünfhundert Euro) genügt die Unterschrift eines der Geschäftsführer.
142532
L
U X E M B O U R G
Jeder Geschäftsführer kann seine Zuständigkeiten für spezielle Aufgaben an einen oder mehrere Bevollmächtige(n)
delegieren. Der entsprechende Geschäftsführer legt die Zuständigkeiten, gegebenenfalls die Vergütung und alle sonstigen
relevanten Bedingungen in Bezug auf den/die Bevollmächtigen fest. Der Rat ist weiter befugt, eine Geschäftsführerordnung
zur Regelung seiner Angelegenheiten zu erlassen. Für den Erlass oder etwaige Änderungen dieser Geschäftsführerordnung
ist eine einstimmige Entscheidung durch den Rat der Geschäftsführer erforderlich.
Art. 12. Der Rat der Geschäftsführer kann aus dem Kreis seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und gegebenenfalls
einen stellvertretenden Vorsitzenden auswählen. Er kann außerdem einen Schriftführer bestimmen, welcher kein Ge-
schäftsführer sein muss und welcher für die Protokolle der Sitzungen der Geschäftsführung verantwortlich ist. Der erste
Vorsitzende kann durch die Generalversammlung der Gesellschafter ernannt werden.
Der Rat der Geschäftsführer wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei Geschäftsführer an dem im Einladungs-
schreiben genannten Ort einberufen. Die Sitzungen der Geschäftsführung finden am Gesellschaftssitz statt, sofern nicht
anders im Einladungsschreiben bestimmt. Der Vorsitzende nimmt den Vorsitz bei allen Sitzungen der Geschäftsführung
wahr; in seiner Abwesenheit kann jedoch der Rat der Geschäftsführer per Mehrheitsbeschluss der Anwesenden einen
anderen Geschäftsführer zum Vorsitzenden pro tempore ernennen.
Die Geschäftsführer erhalten spätestens 24 (vierundzwanzig) Stunden vor dem für die Sitzung vorgesehenen Zeitpunkt
ein schriftliches Einladungsschreiben, außer in dringenden Fällen, in denen Art und Grund der Dringlichkeit im Einla-
dungsschreiben angegeben werden müssen. Auf das Einladungsschreiben kann durch schriftliche Zustimmung, Fax, Email
oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel verzichtet werden. Ein gesondertes Einladungsschreiben ist für
Sitzungen der Geschäftsführung nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort der Sitzung in einem vorangehenden Geschäfts-
führungsbeschluss festgesetzt wurden.
Sind alle Geschäftsführer in einer Sitzung anwesend oder vertreten oder bei Falle schriftlichen Beschlüssen, denen alle
Geschäftsführer zustimmen und die von allen Geschäftsführern unterschrieben werden, ist kein Einladungsschreiben er-
forderlich.
Jeder Geschäftsführer kann sich in den Sitzungen der Geschäftsführung durch einen anderen Geschäftsführer mittels
einer schriftlich oder durch Fax, E-Mail oder ein vergleichbares Kommunikationsmittel erteilten Vollmacht vertreten
lassen. Ein Geschäftsführer kann mehrere Geschäftsführer vertreten.
Jeder Geschäftsführer kann an der Sitzung durch Telefon- oder Videokonferenzschaltung oder durch ein vergleichbares
Kommunikationsmittel teilnehmen, sofern dieses den an der Sitzung teilnehmenden Personen eine ununterbrochene
Verständigung untereinander erlaubt und eine effektive Teilnahme dieser Teilnehmer an der Sitzung ermöglicht. Eine
derartige Teilnahme an einer Sitzung entspricht der persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung. Sollte ein Beschluss im
Wege einer Telefonkonferenz gefasst werden, so soll der Beschluss als in Luxemburg gefasst gelten, sofern die Telekon-
ferenz von Luxemburg aus initiiert wurde.
Der Rat der Geschäftsführer kann nur dann wirksam beraten oder handeln, wenn zumindest die Mehrheit der Ge-
schäftsführer bei einer Sitzung anwesend oder vertreten ist. Beschlüsse der Geschäftsführung werden mit einfacher
Stimmenmehrheit der auf der jeweiligen Sitzung anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Bei Stimmen-
gleichheit hat der Vorsitzende die ausschlaggebende Stimme.
Einstimmige Beschlüsse der Geschäftsführung können auch in Form von Umlaufbeschlüssen gefasst werden, wenn die
Zustimmung schriftlich, durch Fax, E-Mail oder ein vergleichbares Kommunikationsmittel abgegeben wird. Die Gesamtheit
der Unterlagen bildet das Protokoll, das dem Nachweis der Beschlussfassung dient.
Art. 13. Die Protokolle jeder Sitzung des Rates der Geschäftsführung werden vom Vorsitzenden oder oder von zwei
Geschäftsführern unterzeichnet. Kopien oder Auszüge der Protokolle, die in Gerichtsverfahren oder anderweitig vor-
gelegt werden können, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern oder von einer durch den Rat der
Geschäftsführer zu diesem Zweck bestellten Person unterzeichnet.
Art. 14. Der Tod oder der Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchen Gründen auch immer, bewirkt nicht die
Auflösung der Gesellschaft.
Art. 15. Die Haftung der Geschäftsführer bestimmt sich nach Artikel 59 des Gesetzes über Handelsgesellschaften.
D. Gesellschafterversammlung
Art. 16. Hat die Gesellschaft mehrere Gesellschafter, so darf jeder Gesellschafter an gemeinschaftlich zu treffenden
Beschlüssen unabhängig von der von ihm gehaltenen Anzahl an Anteilen mitwirken. Jeder Gesellschafter hat ein Stimm-
recht entsprechend der von ihm gehaltenen Anteile.
Im Falle eines Alleingesellschafters, ist dieser mit allen Zuständigkeiten ausgestattet, die der Gesellschafterversammlung
nach Abschnitt XII des Gesetzes über Handelsgesellschaften eingeräumt werden.
Ein Gesellschafter darf bei Gesellschafterversammlungen der Gesellschafter durch einen Stellvertreter, der nicht selbst
Gesellschafter zu sein braucht, teilnehmen und abstimmen, welchen er mittels einer schriftlichen Vollmacht ernannt hat.
Sofern ein Gesellschafter eine juristische Person ist, handelt er auf Generalversammlungen der Gesellschafter durch
seine/n gesetzlichen Vertreter.
142533
L
U X E M B O U R G
Gemeinschaftliche Beschlüsse sind nur wirksam, wenn sie von Gesellschaftern getroffen werden, die mindestens zwei
Drittel des Kapitals der Gesellschaft vertreten. Beschlüsse zur Änderung der Satzung oder zur Auflösung und Liquidierung
der Gesellschaft dürfen nur von Gesellschaftern getroffen werden, welche mindestens drei Viertel des Kapitals der Ge-
sellschaft vertreten, und unter den Voraussetzungen des Gesetzes über Handelsgesellschaften.
Solange die Anzahl der Gesellschafter der Gesellschaft 25 (fünfundzwanzig) nicht übersteigt, brauchen Beschlüsse der
Gesellschafter nicht auf einer Gesellschafterversammlung gefasst werden, sondern können schriftlich von allen Gesell-
schaftern getroffen werden. In einem solchen Fall wird jedem Gesellschafter ein Entwurf der zu treffenden Beschlüsse
ausgehändigt, welcher von ihm unterschrieben werden soll. Ein solcher schriftlicher Beschluss, der in einer oder mehreren
Ausfertigungen getroffen worden ist, statt eine Generalversammlung abzuhalten, steht einem auf einer Gesellschafter-
versammlung getroffenen Beschluss gleich.
Jede Bezugnahme in dieser Satzung auf Beschlüsse der Generalversammlung ist so auszulegen, dass er sich auch auf
schriftliche Beschlüsse der Gesellschafter bezieht, vorausgesetzt, dass die Anzahl der Gesellschafter nicht 25 (fünfund-
zwanzig) übersteigt.
E. Geschäftsjahr - Konten - Gesetzliche Reserven - Gewinnverteilung
Art. 17. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember desselben Jahres.
Jedes Jahr, am letzten Tag des Monats Dezember werden ein Inventar der Aktiva und Verpflichtungen der Gesellschaft,
sowie eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung erstellt.
Jeder Gesellschafter hat das Recht, das genannte Inventar, die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung am Sitz
der Komplementärin einzusehen.
Art. 18. Das Einkommen der Gesellschaft, nach Abzug der generellen Ausgaben und der Unkosten, der Abschreibungen
und der Provisionen, stellt den Nettogewinn dar.
5% (fünf Prozent) des Nettogewinns werden dem gesetzlichen Reservefonds zugeführt; dieser Abzug ist solange ob-
ligatorisch, bis der Reservefonds 10% (zehn Prozent) des Gesellschaftskapitals umfasst. Der Abzug muss allerdings wieder
bis zur vollständigen Herstellung des Reservefonds aufgenommen werden, wenn dieser, zu welchem Zeitpunkt und aus
welchem Grund auch immer, vermindert wurde.
Der Überschuss des Nettogewinns darf an den/die Gesellschafter im Verhältnis zu der Anzahl der von ihm/ihnen
gehaltenen Anteile ausgeschüttet werden.
F. Auflösung - Liquidation
Art. 19. Die Gesellschaft wird durch den Tod, Geschäftsunfähigkeit, den Entzug der bürgerlichen Rechte, die Auflösung,
der Bankrott oder die Insolvenz eines der Gesellschafter oder des alleinigen Gesellschafter nicht aufgelöst. Die Gesell-
schaft kann jederzeit durch einen Beschluss der Generalversammlung der Gesellschaft aufgelöst werden, der die
Voraussetzungen einer Satzungsänderung erfüllt.
Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren Liquidatoren ausgeführt, welche
keine Gesellschafter sein müssen und welche von der Gesellschafterversammlung, mit der in Artikel 142 des Gesetzes
über Handelsgesellschaften bestimmten Mehrheit, ernannt werden. Der (die) Liquidator(en) verfüg(en) über die weites-
tgehenden Befugnisse zur Realisierung des existierenden Vermögens und Begleichung der Verpflichtungen.
Der nach der Begleichung aller Kosten, Schulden und Ausgaben, welche aufgrund der Liquidation entstehen, zur Ver-
fügung stehende Betrag soll verwendet werden, um die von den Gesellschaftern auf Anteile eingezahlten Beträge
zurückzuzahlen.
Der danach noch bestehende Restbetrag wird an die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Gesellschaftsbeteiligung aus-
gezahlt.
G. Anwendbares Recht
Art. 20. Auf diese Satzung sollen die Gesetze Luxemburgs Anwendung finden, nach welchen sie errichtet und ausgelegt
werden soll.
Alle nicht in dieser Satzung geregelten Punkte werden durch das Gesetz über Handelsgesellschaften geregelt.
H. Übergangsbestimmung
Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tag der Gründung und endet am letzten Tag im Dezember 2014.
I. Zeichnung und Einzahlung
Die Anteile wurden wie folgt gezeichnet:
Nextech Holding AG, vorbenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10’810 Anteile
Prof. Dr. David Morse Livingston, vorbenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2’220 Anteile
Prof. Dr. William G. Kaelin, vorbenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
594 Anteile
Prof. Dr. Glenn Dranoff, vorbenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
594 Anteile
Dr. Charles L. Sawyers, vorbenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
594 Anteile
142534
L
U X E M B O U R G
Prof. Dr. Karl-Heinz Altmann, vorbenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
594 Anteile
Prof. Dr. Paul Workman, vorbenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
594 Anteile
Dr. Thomas Lips, vorbenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 Anteile
Dr. Thilo Schroeder, vorbenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3'500 Anteile
GESAMT: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20’000 Anteile
Die Anteile wurden vollständig bis zu einem Betrag von USD 1 (ein US-Dollar) je Anteil durch Barzahlung in Höhe
von USD 20‘000 (zwanzigtausend US-Dollar) eingezahlt.
Als Ergebnis steht ab dem jetzigen Zeitpunkt der Gesellschaft der Betrag von USD 20‘000 (zwanzigtausend US-Dollar)
zur Verfügung, was von dem Notar, welcher diese Urkunde unterzeichnet, bestätigt wird.
J. Kosten
Die der Gesellschaft aufgrund ihrer Gründung entstandenen und von ihr zu tragenden Auslagen, Gebühren, Honorare
oder Kosten jeglicher Art werden auf ca. EUR 1.800.- geschätzt.
K. Ausserordentliche Gesellschafterversammlung
Nachdem diese Satzung soeben verabschiedet wurde, entscheiden die oben erwähnten Gesellschafter, eine Gesell-
schafterversammlung abzuhalten. Nachdem festgestellt wurde, dass die Gesellschafterversammlung wirksam konstitutiert
wurde, hat diese die folgenden Beschlüsse gefasst:
1. Der Sitz der Gesellschaft ist in 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Großherzogtum Luxemburg.
2. Als Geschäftsführer (gérant) der Gesellschaft für eine unbestimmte Dauer werden folgende Personen ernannt:
- Dr. Thomas Lips, geboren am 3. Juli 1949 in Zürich, Schweiz, mit professioneller Adresse in Scheuchzerstrasse 35,
CH 8006 Zürich, Schweiz; und
- Marc Kriegsmann, geboren am 12. Februar 1976 in Lich, Deutschland, mit professioneller Adresse in 1c, rue Gabriel
Lippmann, L-5365 Munsbach, Großherzogtum Luxemburg; und
- Christoph Kraiker geboren am 2. Juli 1980 in Trier, Deutschland mit professioneller Adresse in 1c, rue Gabriel
Lippmann, L-5365 Munsbach, Großherzogtum Luxemburg.
Vorsitzender des Rates der Geschäftsführer ist Dr. Thomas Lips.
Worüber diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen wurde.(enthaltend
zwei Blankostellen).
Der beurkundende Notar, der die englische Sprache beherrscht, bestätigt hiermit, dass die vorliegende Urkunde auf
Verlangen der erschienenen Partei in englischer Sprache mit nachfolgender deutscher Übersetzung aufgenommen wird;
auf Verlangen der erschienenen Partei und im Fall einer Abweichungen der englischen von der deutschen Fassung, kommt
der englischen Fassung Vorrang zu.
Die vorstehende Niederschrift ist dem Vertreter der erschienenen Partei, welcher dem Notar mit Name, Vorname
und Wohnsitz bekannt ist, verlesen worden und vom Notar zusammen mit diesem Vertreter der erschienen Partei
unterzeichnet worden.
Gezeichnet: C. JUNK und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 août 2014. Relation: LAC/2014/39277. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - Der Gesellschaft auf Begehr erteilt.
Luxemburg, den 26. August 2014.
Référence de publication: 2014135675/443.
(140153850) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2014.
ColEssen S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 116.307.
<i>Dépôt rectificatif du dépôt L120207936 enregistré et déposé le 03/12/2012i>
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014136587/11.
(140155375) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2014.
142535
L
U X E M B O U R G
PS1 Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 351.800,00.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 208, Val des Bons-Malades.
R.C.S. Luxembourg B 179.585.
In the year two thousand and fourteen, the seventeenth day of April.
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
was held
an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of PS1 Luxco S.à r.l., a private limited liability
company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,
having its registered office at 208, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered
with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 179.585 and having a share capital of two
hundred ninety-six thousand five hundred United States Dollars (USD 296,500.-) (the Company).
The Company has been incorporated pursuant to a deed of Maître Henri HELLINCKX, a notary resident in Luxem-
bourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 12 July 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
n°2486 of 8 October 2013. The articles of association of the Company (the Articles) were amended most recently
pursuant to a deed received by Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette, on 31 March 2014, not yet
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
THERE APPEARED:
1. SCP III AIV One, L.P., an exempted limited partnership under the laws of the Cayman Islands, having its registered
office at P.O. Box 309, Ugland House, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands, registered in the Cayman Islands with
the Registrar of Companies under number 32986, acting through its general partner, SC Partners III AIV One GP Cor-
poration, an exempted company under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at P.O. Box 309, Ugland
House, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands, registered in the Cayman Islands with the Registrar of Companies
under number 224791 (Shareholder I);
2. G14M5 PATCO Equity, L.L.C., a limited liability company under the laws of the State of Delaware, having its principal
place of business at 71 South Wacker Drive, 47
th
Floor, Chicago, Illinois 60606, United States of America;
3. T11M5 PATCO Equity, L.L.C., a limited liability company under the laws of the State of Delaware, having its principal
place of business at 71 South Wacker Drive, 47
th
Floor, Chicago, Illinois 60606, United States of America;
4. GP09GV (Edison) Ltd., a corporation under the laws of the Province of Alberta, having its registered office at Suite
1100, 10830 Jasper Avenue, Edmonton, Alberta T5J 2B3, Canada;
5. GP09PX (Edison) Ltd., a corporation under the laws of the Province of Alberta, having its registered office at Suite
1100, 10830 Jasper Avenue, Edmonton, Alberta T5J 2B3, Canada;
6. Vesey Street Fund IV (ERISA) Blocker, L.P., a limited partnership under the laws of the Cayman Islands, having its
principal place of business at 1 University Square Drive, Princeton, New Jersey 08540, United States of America, acting
through its general partner;
7. MTI Co-Invest, LLC, a limited liability company under the laws of the State of Delaware, having its principal place
of business at 1 University Square Drive, Princeton, New Jersey 08540, United States of America;
8. VCVC III LLC, a limited liability company under the laws of the State of Delaware, having its principal place of business
at 505 Fifth Avenue, Suite 900, Seattle, Washington 98104, United States of America;
9. PineBridge Structured Capital Partners II, L.P., a limited partnership under the laws of the State of Delaware, having
its principal place of business at 399 Park Avenue, 4
th
Floor, New York, New York 10022, United States of America;
10. PineBridge Structured Capital Partners Offshore II, L.P., a limited partnership under the laws of the Cayman Islands,
having its principal place of business at 399 Park Avenue, 4
th
Floor, New York, New York 10022, United States of
America, acting through its general partner;
11. PineBridge Structured Capital Partners Offshore II-A, L.P., a limited partnership under the laws of the Cayman
Islands, having its principal place of business at 399 Park Avenue, 4
th
Floor, New York, New York 10022, United States
of America, acting through its general partner;
12. American International Group, Inc., Retirement Plan Master Trust, a trust under the laws of the Commonwealth
of Massachusetts, acting through its trustee, having its principal place of business at 399 Park Avenue, 4
th
Floor, New
York, New York 10022, United States of America;
13. Honeywell International Inc. Master Retirement Trust, a trust under the laws of the State of New Jersey, acting
through its investment advisor, having its principal place of business at 101 Columbia Road, Morristown, New Jersey
07962, United States of America;
14. Soper Investments Limited, a limited liability company under the laws of the Bailiwick of Guernsey, having its
registered office at Regency Court, Glategny Esplanade, St. Peter Port, Guernsey GY1 1WW;
142536
L
U X E M B O U R G
15. West Maple Ventures, LLC, a limited liability company under the laws of the State of Delaware, having its principal
place of business at 1603 Orrington Avenue, Suite 810, Evanston, Illinois 60201, United States of America;
16. Brenthurst Private Equity IV US, LP, an international limited partnership under the laws of the British Virgin Islands,
having its principal place of business at 1 Charterhouse Street, London EC1N 65A, United Kingdom, acting through its
general partner;
17. Mark Pu, professionally residing at c/o PATCO Investors, L.L.C. 71 South Wacker Drive, 47
th
Floor Chicago, IL
60606, United States of America;
18. TPOP-MTI, LLC, a limited liability company under the laws of the State of Delaware, having its principal place of
business at 2711 CENTERVILLE RD STE 400, Wilmington 19808, United States of America; and
19. Rellim Trust Company, LLC, a limited liability company under the laws of the State of Delaware, having its principal
place of business at 160 GREENTREE DR STE 101, Dover 19904, United States of America (together with the share-
holders listed from 1 to 18 above, the Shareholders),
hereby represented by Régis Galiotto, notary’s clerk, residing professionally in Luxembourg, by virtue of powers of
attorney given under private seal.
Such powers of attorney, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing
parties and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the regis-
tration authorities.
The appearing parties, as represented above, have requested the undersigned notary to record the following:
I. The Shareholders hold all the shares in the share capital of the Company;
II. The agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Waiver of the convening notice;
2. Increase of the share capital of the Company by an amount of fifty-five thousand three hundred United States dollars
(USD 55,300.-) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of two hundred ninety-six
thousand five hundred United States dollars (USD 296,500.-) represented by represented by
(i) twenty-nine thousand six hundred and fifty (29,650) class A units (the "Class A Units");
(ii) twenty-nine thousand six hundred and fifty (29,650) class B units (the "Class B Units");
(iii) twenty-nine thousand six hundred and fifty (29,650) class C units (the "Class C Units");
(iv) twenty-nine thousand six hundred and fifty (29,650) class D units (the "Class D Units");
(v) twenty-nine thousand six hundred and fifty (29,650) class E units (the "Class E Units");
(vi) twenty-nine thousand six hundred and fifty (29,650) class F units (the "Class F Units");
(vii) twenty-nine thousand six hundred and fifty (29,650) class G units (the "Class G Units");
(viii) twenty-nine thousand six hundred and fifty (29,650) class H units (the "Class H Units");
(ix) twenty-nine thousand six hundred and fifty (29,650) class I units (the "Class I Units"); and
(x) twenty-nine thousand six hundred and fifty (29,650) class J units (the "Class J Units"),
to three hundred fifty-one thousand eight hundred United States dollars (USD 351,800.-) by way of the issuance of
fifty-five thousand three hundred (55,300) units equally divided into each of class of units in the share capital of the
Company, i.e. five thousand five hundred and thirty (5,530) units in each class of units, having a nominal value of one
United States Dollar (USD 1.-) each;
3. Subscription and payment of the share capital increase adopted above;
4. Subsequent amendment of article 16.1 of the Articles;
5. Amendment to the shareholder register of the Company in order to reflect the above changes with power and
authority given to any manager of the Company, any lawyer or employee of Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l. and any
employee of UNSWORTH & ASSOCIATES S.àr.l. to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly
issued shares in the shareholder register of the Company;
6. Miscellaneous.
III. The Meeting resolves to take the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The entirety of the share capital of the Company being present or represented at the Meeting, the Meeting waives the
convening notices, the Shareholders represented considering themselves as duly convened and declaring having perfect
knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance.
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of fifty-five thousand three hundred
United States dollars (USD 55,300.-) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of two
hundred ninety-six thousand five hundred United States dollars (USD 296,500.-) represented by represented by
(i) twenty-nine thousand six hundred and fifty (29,650) class A units (the "Class A Units");
142537
L
U X E M B O U R G
(ii) twenty-nine thousand six hundred and fifty (29,650) class B units (the "Class B Units");
(iii) twenty-nine thousand six hundred and fifty (29,650) class C units (the "Class C Units");
(iv) twenty-nine thousand six hundred and fifty (29,650) class D units (the "Class D Units");
(v) twenty-nine thousand six hundred and fifty (29,650) class E units (the "Class E Units");
(vi) twenty-nine thousand six hundred and fifty (29,650) class F units (the "Class F Units");
(vii) twenty-nine thousand six hundred and fifty (29,650) class G units (the "Class G Units");
(viii) twenty-nine thousand six hundred and fifty (29,650) class H units (the "Class H Units");
(ix) twenty-nine thousand six hundred and fifty (29,650) class I units (the "Class I Units"); and
(x) twenty-nine thousand six hundred and fifty (29,650) class J units (the "Class J Units"),
to three hundred fifty-one thousand eight hundred United States dollars (USD 351,800.-) by way of the issuance of
fifty-five thousand three hundred (55,300) units equally divided into each of class of units in the share capital of the
Company, i.e. five thousand five hundred and thirty (5,530) units in each class of units, having a nominal value of one
United States Dollar (USD 1.-) each.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon, Shareholder I, represented as stated above, declares to subscribe for fifty-five thousand three hundred
(55,300) units equally divided into each of class of units in the share capital of the Company, i.e. five thousand five hundred
and thirty (5,530) units in each class of units, having a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each, and to
fully pay them up by a contribution in cash amounting to five hundred fifty-three thousand United States Dollars (USD
553,000.-) (the Contribution).
The Contribution in an aggregate amount of five hundred fifty-three thousand United States Dollars (USD 553,000.-)
is to be allocated as follows:
(i) an amount of fifty-five thousand three hundred United States dollars (USD 55,300.-) is to be allocated to the share
capital account of the Company; and
(ii) an amount of four hundred ninety-seven thousand seven hundred United States Dollars (USD 497,700.-) is to be
allocated to the share premium account of the Company attached to the shares.
The amount of five hundred fifty-three thousand United States Dollars (USD 553,000.-) corresponding to the Con-
tribution is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges.
<i>Third resolutioni>
As a result of the foregoing resolutions, the Meeting resolves to amend Article 16.1 of the Articles so that it reads
henceforth as follows:
“ 16. Capital.
16.1 The share capital of the company is three hundred fifty-one thousand eight hundred United States dollars (USD
351,800.-) divided into
(i) thirty-five thousand one hundred and eighty (35,180) class A units (the "Class A Units");
(ii) thirty-five thousand one hundred and eighty (35,180) class B units (the "Class B Units");
(iii) thirty-five thousand one hundred and eighty (35,180) class C units (the "Class C Units");
(iv) thirty-five thousand one hundred and eighty (35,180) class D units (the "Class D Units");
(v) thirty-five thousand one hundred and eighty (35,180) class E units (the "Class E Units");
(vi) thirty-five thousand one hundred and eighty (35,180) class F units (the "Class F Units");
(vii) thirty-five thousand one hundred and eighty (35,180) class G units (the "Class G Units");
(viii) thirty-five thousand one hundred and eighty (35,180) class H units (the "Class H Units");
(ix) thirty-five thousand one hundred and eighty (35,180) class I units (the "Class I Units"); and
(x) thirty-five thousand one hundred and eighty (35,180) class J units (the "Class J Units");
with a nominal value of one United States dollar (USD 1.00) each.
The rights and obligations attached to the Classes of Units shall be identical except to the extent otherwise provided
by the articles or by the Commercial Companies Act 1915.
In addition to the share capital, there may be set up (a) premium account(s) into which any premium paid on any unit
(s) and/or Classe(s) of Units in addition to its(their) nominal value is transferred. The amount of the premium account
may be used for the purpose of the redemption of any Class(es) of Units as per article 17. of these articles, to offset any
net realized losses, to make distributions to the members or to allocate funds to the legal reserve.“
<i>Fourth resolutioni>
The Meeting resolves to amend to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes
and to authorise and empower any manager of the Company, any lawyer or employee of Loyens & Loeff Luxembourg
142538
L
U X E M B O U R G
S.à r.l., each acting individually, to proceed on behalf of the Company, to the registration of the newly issued shares in
the register of shareholders of the Company.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever borne by the Company, as a result of the presently
stated, are evaluated at two thousand Euros (2,000.- EUR).
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the proxyholder of the appearing parties
signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille quatorze, le dix-septième jour d’avril,
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
s’est tenue
une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) des associés de PS1 Luxco S.à r.l., une société à responsabilité
limitée régie et organisée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social est établi au 208, Val des
Bons Malades, L-2121 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des So-
ciétés de Luxembourg sous le numéro B 179.585, et disposant d’un capital de deux cent quatre-vingt-seize mille cinq
cents dollars américains (USD 296.500,-) (la Société).
La Société a été constituée le 12 juillet 2013 suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Lu-
xembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°2486 du 8 octobre
2013. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois le 31 mars 2014, suivant un acte de
Maître Francis Kesseler, susmentionné, en voie de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
ONT COMPARU:
1. SCP III AIV One, L.P., une exempted limited partnership régie selon les lois des Iles Caïmans, ayant son siège social
au P.O. Box 309, Ugland House, Grand Caïman KY1-1104, Iles Caïmans, enregistré aux Iles Caïmans au Registre des
Sociétés sous le numéro 32986, agissant par l’intermédiaire de son commandité, SC Partners III AIV One GP Corporation,
une exempted company régie selon le droit des Iles Caïmans, ayant son siège social au P.O. Box 309, Ugland House,
Grand Caïman KY1-1104, Iles Caïmans, enregistré aux Iles Caïmans au Registre des Sociétés sous le numéro 224791
(l’Associé I);
2. G14M5 PATCO Equity, L.L.C., une société à responsabilité limitée régie selon les lois de l’Etat du Delaware, dont
l’établissement principal se situe au 71 South Wacker Drive, 47
th
Floor, Chicago, Illinois 60606, Etats-Unis d’Amérique;
3. T11M5 PATCO Equity, L.L.C., une société à responsabilité limitée régie selon les lois de l’Etat du Delaware, dont
l’établissement principal se situe au 71 South Wacker Drive, 47
th
Floor, Chicago, Illinois 60606, Etats-Unis d’Amérique;
4. GP09GV (Edison) Ltd., une société régie selon les lois de la Province de l’Alberta, ayant son siège social à Suite 1100,
10830 Jasper Avenue, Edmonton, Alberta T5J 2B3, Canada;
5. GP09PX (Edison) Ltd., une société régie selon les lois de la Province de l’Alberta, ayant son siège social à Suite 1100,
10830 Jasper Avenue, Edmonton, Alberta T5J 2B3, Canada;
6. Vesey Street Fund IV (ERISA) Blocker, L.P., une limited partnership régie selon les lois des Iles Caïmans, dont
l’établissement principal se situe au 1 University Square Drive, Princeton, New Jersey 08540, Etats-Unis d’Amérique,
agissant par l’intermédiaire de son commandité;
7. MTI Co-Invest, LLC, une société à responsabilité limitée régie selon les lois de l’Etat du Delaware, dont l’établisse-
ment principal se situe au 1 University Square Drive, Princeton, New Jersey 08540, Etats-Unis d’Amérique;
8. VCVC III LLC, une société à responsabilité limitée régie selon les lois de l’Etat du Delaware, dont l’établissement
principal se situe au 505 Fifth Avenue, Suite 900, Seattle, Washington 98104, Etats-Unis d’Amérique;
9. PineBridge Structured Capital Partners II, L.P., une limited partnership régie selon les lois de l’Etat du Delaware,
dont l’établissement principal se situe au 399 Park Avenue, 4
th
Floor, New York, New York 10022, Etats-Unis d’Amérique;
10. PineBridge Structured Capital Partners Offshore II, L.P., une limited partnership régie selon les lois des Iles Caïmans,
dont l’établissement principal se situe au 399 Park Avenue, 4
th
Floor, New York, New York 10022, Etats-Unis d’Amérique,
agissant par l’intermédiaire de son commandité;
142539
L
U X E M B O U R G
11. PineBridge Structured Capital Partners Offshore II-A, L.P., une limited partnership régie selon les lois des Iles
Caïmans, dont l’établissement principal se situe au 399 Park Avenue, 4
th
Floor, New York, New York 10022, Etats-Unis
d’Amérique, agissant par l’intermédiaire de son commandité;
12. American International Group, Inc., Retirement Plan Master Trust, un trust en vertu des lois du Commonwealth
de Massachusetts, agissant par l’intermédiaire de son trustee, dont l’établissement principal se situe au 399 Park Avenue,
4
th
Floor, New York, New York 10022, Etats-Unis d’Amérique;
13. Honeywell International Inc. Master Retirement Trust, un trust en vertu des lois de l’Etat du New Jersey, agissant
par l’intermédiaire de son conseiller en investissement, dont l’établissement principal se situe au 101 Columbia Road,
Morristown, New Jersey 07962, Etats-Unis d’Amérique;
14. Soper Investments Limited, une société à responsabilité limitée régie selon les lois du Bailliage de Guernsey, ayant
son siège social au Regency Court, Glategny Esplanade, St. Peter Port, Guernsey GY1 1WW;
15. West Maple Ventures, LLC, une société à responsabilité limitée régie selon les lois de l’Etat du Delaware, dont
l’établissement principal se situe au 1603 Orrington Avenue, Suite 810, Evanston, Illinois 60201, Etats-Unis d’Amérique;
16. Brenthurst Private Equity IV US, LP, une international limited partnership régie selon les lois des Iles Vierges
Brittaniques, dont l’établissement principal se situe au 1 Charterhouse Street, Londres EC1N 65A, Royaume-Uni, agissant
par l’intermédiaire de son commandité;
17. Mark Pu, dont l’adresse professionnelle se situe au c/o PATCO Investors, L.L.C. 71 South Wacker Drive, 47
th
Floor Chicago, IL 60606, Etats-Unis d’Amérique;
18. TPOP-MTI, LLC une société à responsabilité limitée régie selon les lois de l’Etat du Delaware, dont l’établissement
principal se situe au 2711 CENTERVILLE RD STE 400, Wilmington 19808, Etats-Unis d’Amérique; et
19. Rellim Trust Company, LLC, une société à responsabilité limitée régie selon les lois de l’Etat du Delaware, dont
l’établissement principal se situe au 160 GREENTREE DR STE 101, Dover 19904, Etats-Unis d’Amérique (ensembles avec
les associés numérotés de 1 à 18 ci-dessus, les Associés),
ici représentés par Régis Galiotto, clerc de notaire, de résidence professionnelle à Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, en vertu de procurations données sous seing privé.
Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire agissant au nom des parties comparantes
et par le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées ensembles avec celui-ci auprès
des autorités d’enregistrement.
Les parties comparantes, tel que représentées ci-dessus, ont requis du notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. que les Associés détiennent toutes les parts sociales dans le capital social de la Société;
II. que l’ordre du jour de l’Assemblée est libellé de la manière suivante:
1. Renonciation de l’avis de convocation;
2. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de cinquante-cinq mille trois cents dollars américains
(USD 55,300,-) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de deux cent quatre-vingt-seize mille
cinq cents dollars américains (USD 296.500,-) représenté par
(i) vingt-neuf mille six cent cinquante (29.650) parts sociales de classe A («les Parts Sociales de Classe A»);
(ii) vingt-neuf mille six cent cinquante (29.650) parts sociales de classe B («les Parts Sociales de Classe B»);
(iii) vingt-neuf mille six cent cinquante (29.650) parts sociales de classe C («les Parts Sociales de Classe C»);
(iv) vingt-neuf mille six cent cinquante (29.650) parts sociales de classe D («les Parts Sociales de Classe D»);
(v) vingt-neuf mille six cent cinquante (29.650) parts sociales de classe E («les Parts Sociales de Classe E»);
(vi) vingt-neuf mille six cent cinquante (29.650) parts sociales de classe F («les Parts Sociales de Classe F»);
(vii) vingt-neuf mille six cent cinquante (29.650) parts sociales de classe G («les Parts Sociales de Classe G»);
(viii) vingt-neuf mille six cent cinquante (29.650) parts sociales de classe H («les Parts Sociales de Classe H»);
(ix) vingt-neuf mille six cent cinquante (29.650) parts sociales de classe I («les Parts Sociales de Classe I»); et
(x) vingt-neuf mille six cent cinquante (29.650) parts sociales de classe J («les Parts Sociales de Classe J»),
à un montant de trois cent cinquante-et-un mille huit cents dollars américains (351.800,-) par voie d’émission de
cinquante-cinq mille trois cents (55.300) parts sociales réparties équitablement entre chaque classe de parts sociales dans
le capital social de la Société, i.e. cinq mille cinq cent trente (5.530) parts sociales dans chaque classe de parts sociales,
ayant une valeur nominale d’un dollar américain (USD 1,-) chacune;
3. Souscription et libération de l’augmentation de capital social décidée ci-dessus;
4. Modification subséquente de l’article 16.1 des Statuts;
5. Modification du registre des associés de la Société afin d’y faire figurer les modifications ci-dessus et donne pouvoir
et autorité à tout gérant de la Société, à tout avocat ou employé de Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l., et à tout employé
de UNSWORTH & ASSOCIATES S.àr.l., afin de procéder au nom et pour le compte de la Société à l’enregistrement des
parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société;
6. Divers.
142540
L
U X E M B O U R G
III. L’Assemblée décide de prendre les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’intégralité du capital social de la Société étant représenté à l’Assemblée, l’Assemblée renonce aux avis de convocation,
les Associés représentés se considérant comme dûment convoqués et déclarent avoir parfaite connaissance de l’ordre
du jour qui leur a été communiqué en avance.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de cinquante-cinq mille trois cents dollars
américains (USD 55,300,-) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de deux cent quatre-vingt-
seize mille cinq cents dollars américains (USD 296.500,-) représenté par
(i) vingt-neuf mille six cent cinquante (29.650) parts sociales de classe A («les Parts Sociales de Classe A»);
(ii) vingt-neuf mille six cent cinquante (29.650) parts sociales de classe B («les Parts Sociales de Classe B»);
(iii) vingt-neuf mille six cent cinquante (29.650) parts sociales de classe C («les Parts Sociales de Classe C»);
(iv) vingt-neuf mille six cent cinquante (29.650) parts sociales de classe D («les Parts Sociales de Classe D»);
(v) vingt-neuf mille six cent cinquante (29.650) parts sociales de classe E («les Parts Sociales de Classe E»);
(vi) vingt-neuf mille six cent cinquante (29.650) parts sociales de classe F («les Parts Sociales de Classe F»);
(vii) vingt-neuf mille six cent cinquante (29.650) parts sociales de classe G («les Parts Sociales de Classe G»);
(viii) vingt-neuf mille six cent cinquante (29.650) parts sociales de classe H («les Parts Sociales de Classe H»);
(ix) vingt-neuf mille six cent cinquante (29.650) parts sociales de classe I («les Parts Sociales de Classe I»); et
(x) vingt-neuf mille six cent cinquante (29.650) parts sociales de classe J («les Parts Sociales de Classe J»),
à un montant de trois cent cinquante-et-un mille huit cents dollars américains (351.800,-) par voie d’émission de
cinquante-cinq mille trois cents (55.300) parts sociales réparties équitablement entre chaque classe de parts sociales dans
le capital social de la Société, i.e. cinq mille cinq cent trente (5.530) parts sociales dans chaque classe de parts sociales,
ayant une valeur nominale d’un dollar américain (USD 1,-) chacune.
<i>Souscription - Libérationi>
Par conséquent, l’Associé I, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à cinquante-cinq mille trois cents
(55.300) parts sociales réparties équitablement entre chaque classe de parts sociales dans le capital social de la Société,
i.e. cinq mille cinq cent trente (5.530) parts sociales dans chaque classe de parts sociales, ayant une valeur nominale d’un
dollar américain (USD 1,-) chacune, et de les libérer intégralement par un apport en numéraire d’un montant de cinq cent
cinquante-trois mille dollars américains (USD 553.000,-) (l’Apport).
L’Apport d’un montant de cinq cent cinquante-trois mille dollars américains (USD 553.000,-) sera réparti comme suit:
(i) un montant de cinquante-cinq mille trois cents dollars américains (USD 55.300,-) sera alloué au compte de capital
social de la Société;
(ii) un montant de quatre cent quatre-vingt-dix-sept mille sept cents dollars américains (USD 497.700,-) sera alloué au
compte de prime d’émission de la Société attaché aux parts sociales.
Le montant de cinq cent cinquante-trois mille dollars américains (USD 553.000,-) correspondant à l’Apport est à la
libre disposition de la Société, tel qu'il a été démontré au notaire instrumentant, qui le reconnaît expréssement.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence des résolutions qui précèdent, l’Assemblée décide de modifier l’article 16.1 des Statuts, qui aura
désormais la teneur suivante:
“ 16. Capital.
16.1 Le capital social de la société est fixé à trois cent cinquante-et-une mille huit cents dollars américains (USD
351.800,-) réparti comme suit
(i) trente-cinq-mille cent quatre-vingt (35.180) parts sociales de classe A («les Parts Sociales de Classe A»);
(ii) trente-cinq-mille cent quatre-vingt (35.180) parts sociales de classe B («les Parts Sociales de Classe B»);
(iii) trente-cinq-mille cent quatre-vingt (35.180) parts sociales de classe C («les Parts Sociales de Classe C»);
(iv) trente-cinq-mille cent quatre-vingt (35.180) parts sociales de classe D («les Parts Sociales de Classe D»);
(v) trente-cinq-mille cent quatre-vingt (35.180) parts sociales de classe E («les Parts Sociales de Classe E»);
(vi) trente-cinq-mille cent quatre-vingt (35.180) parts sociales de classe F («les Parts Sociales de Classe F»);
(vii) trente-cinq-mille cent quatre-vingt (35.180) parts sociales de classe G («les Parts Sociales de Classe G»);
(viii) trente-cinq-mille cent quatre-vingt (35.180) parts sociales de classe H («les Parts Sociales de Classe H»);
(ix) trente-cinq-mille cent quatre-vingt (35.180) parts sociales de classe I («les Parts Sociales de Classe I»); et
(x) trente-cinq-mille cent quatre-vingt (35.180) parts sociales de classe J («les Parts Sociales de Classe J»),
ayant une valeur nominale de un dollar américain (USD 1,-) chacune.
142541
L
U X E M B O U R G
Les droits et les obligations attachés aux Classes de Parts Sociales seront identiques sous réserve de dispositions
contraires prévus par les statuts ou par la Loi sur les Sociétés Commerciales de 1915.
En complément du capital social, il pourra être établi un (des) compte(s) de prime d’émission dans lequel (lesquels)
toute prime d’émission versée à chaque part sociale ou Classe de Parts Sociales en complément de sa (leur) valeur
nominale sera transféré. Le montant du compte de prime d’émission pourra être utilisé afin de racheter toute Classe de
Parts Sociales conformément à l’article 17 des présents statuts, afin de compenser toutes pertes nettes réalisées, d’ef-
fectuer des distributions aux associés ou d’allouer des fonds à la réserve légale.“
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée décide de modifier le registre des associés de la Société afin d’y faire figurer les modifications ci-dessus
et donne pouvoir et autorité à tout gérant de la Société, à tout avocat ou employé de Loyens & Loeff Luxembourg S.à
r.l., chacun agissant individuellement, afin de procéder au nom et pour le compte de la Société à l’enregistrement des
parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en
conséquence du présent acte sont estimés approximativement à deux mille Euros (2.000.- EUR).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare que les parties comparantes l’ont requis de documenter
le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française. A la requête des mêmes parties, et en cas de divergence
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, ledit mandataire a signé avec nous, le notaire, l’original
du présent acte.
Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 25 avril 2014. Relation: LAC/2014/19393. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 26 juin 2014.
Référence de publication: 2014135744/355.
(140154109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2014.
NSS New Luxco S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 143.660.
the year two thousand and fourteen, on the twenty-first day of August.
Before Maître Martine WEINANDY, notary residing in Clervaux (Grand Duchy of Luxembourg) acting in replacement
of Maître Léonie GRETHEN, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), to whom remains the present
deed.
Is held
an extraordinary general meeting of the shareholders of the joint stock company (société anonyme) incorporated and
existing in the Grand-Duchy of Luxembourg under the name “NSS New Luxco S.A.” (hereinafter, the Company), with
registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register under number B 143660, incorporated pursuant to a deed of Me Francis KESSELER, notary residing in Esch-sur-
Alzette, dated November 28, 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 91 dated
January 15, 2009, and whose articles of incorporation have been last amended pursuant to a deed of Me Francis KESSELER,
notary residing in Esch-sur-Alzette, dated April 12, 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
number 1313 dated May 26, 2012.
The meeting is chaired by Mrs Monique Drauth, notary’s clerk, professionally residing in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Mrs Sylvie Dechamp, notary’s clerk, professionally residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mrs Rachida Martinot, employee, professionally residing in Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to act:
I. That the shareholders represented by virtue of three (3) proxies given under private seal on August 18, 2014, and
the number of their shares are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the
undersigned notary. The said list as well as the proxies will be registered with these minutes.
142542
L
U X E M B O U R G
II. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation representing the entire share capital of the
Company, presently set at sixty-two thousand thirty-nine Euro (EUR 62.039,-) are represented at the present general
meeting so that the meeting can validly decide on all the items of its agenda.
III. That the agenda of the meeting is the following:
1. Change of registered office of the Company from 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg to 1B, Heienhaff,
L-1736 Senningerberg.
2. Subsequent amendment of the first and second paragraphs of article 3 of the Company’s articles to give it henceforth
the following wording:
“ Art. 3. The registered office of the Company is established in the municipality of Niederanven.
It may be transferred to any other address in the same municipality by a decision of the Board of Directors.”
3. Amendment of the following definitions in article 2 of the Company’s articles:
“BRB Investor means BRB Luxembourg S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée)
established and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade
and Companies Register under number B 143659,”
“Company means the present company as defined in article 1,”
“Evergreen Investor means Evergreen Real Estate Partners Europe S.à r.l., a private limited liability company (société
à responsabilité limitée) established and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and registered with
the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 121655,”
“Feeder means NSS Feeder S.A., a joint stock company (société anonyme) established and existing under the laws of
the Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B
143661,”
“MIV means NSS Management Investment Vehicle S.A., a joint stock company (société anonyme) established and
existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register under number B 143658,”
“Pelican means NSS Pelican S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) established and
existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register under number B 143793,”
“Sub Feeder means NSS Sub Feeder S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) esta-
blished and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and
Companies Register under number B 143792,”
4. Dismissal of Mr Alan Dundon, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg as category
B director of the Company with immediate effect.
5. Appointment of Mr Paul Bijoux, Accountant, born on February 18, 1984 in Liverpool (UK), professionally residing
at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg as category B director of the Company with immediate effect and for a period of
six (6) years.
IV. The meeting, after deliberation, unanimously takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting resolves to change the registered office of the Company from 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
to 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg.
<i>Second resolutioni>
The meeting resolves to amend the first and second paragraphs of article 3 of the Company’s articles to give them
henceforth the following wording:
“ Art. 3. The registered office of the Company is established in the municipality of Niederanven.
It may be transferred to any other address in the same municipality by a decision of the Board of Directors.”
<i>Third resolutioni>
The meeting resolves to amend the following definitions in article 2 of the Company’s articles:
“BRB Investor means BRB Luxembourg S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée)
established and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade
and Companies Register under number B 143659,”
“Company means the present company as defined in article 1,”
“Evergreen Investor means Evergreen Real Estate Partners Europe S.à r.l., a private limited liability company (société
à responsabilité limitée) established and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and registered with
the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 121655,”
142543
L
U X E M B O U R G
“Feeder means NSS Feeder S.A., a joint stock company (société anonyme) established and existing under the laws of
the Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B
143661,”
“MIV means NSS Management Investment Vehicle S.A., a joint stock company (société anonyme) established and
existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register under number B 143658,”
“Pelican means NSS Pelican S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) established and
existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register under number B 143793,”
“Sub Feeder means NSS Sub Feeder S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) esta-
blished and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and
Companies Register under number B 143792,”
<i>Fourth resolutioni>
The meeting resolves to dismiss Mr Alan Dundon, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Lu-
xembourg as category B director of the Company with immediate effect.
<i>Fifth resolutioni>
The meeting resolves to appoint Mr Paul Bijoux, Accountant, born on February 18, 1984 in Liverpool (UK), profes-
sionally residing at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg as category B director of the Company with immediate effect
and for a period of six (6) years.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the
above resolutions are estimated at one thousand two hundred Euro (EUR 1,200.-).
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxy holder of
the above appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the
same person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date first written above.
The document having been read to the members of the bureau and to the proxy holder of the appearing persons, who
are known to the notary by their full name, civil status and residence, they signed together with Us, the notary, the present
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille quatorze, le vingt et un août.
Par-devant Maître Martine WEINANDY, notaire de résidence à Clervaux (Grand-Duché de Luxembourg), agissant en
remplacement de Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), laquelle
dernière restera dépositaire de la présente minute.
S'est réunie
l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie au Grand-Duché de Luxembourg
sous la dénomination «NSS New Luxco S.A.» (ci-après, la Société), ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882
Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 143660,
constituée par acte de Me Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 28 novembre 2008,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 91 du 15 janvier 2009, et dont les statuts ont été
modifiés pour la dernière fois par acte de Me Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 12
avril 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1313 du 26 mai 2012.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Mme Monique Drauth, clerc de notaire, demeurant professionnellement
à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Mme Sylvie Dechamp, clerc de notaire, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Mme Rachida Martinot, salariée, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président déclare et prie le notaire d’acter:
I. Que les actionnaires représentés, en vertu de trois (3) procurations données sous-seing privé le 18 août 2014, et le
nombre d’actions détenues sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur
et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que les procurations, resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
142544
L
U X E M B O U R G
II. Qu’il appert de cette liste de présence que la totalité des actions, représentant l’intégralité du capital social actuel-
lement fixé à soixante-deux mille trente-neuf Euro (EUR 62.039,-) sont représentées à la présente assemblée générale
extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à son ordre du jour.
III. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Transfert du siège social de la Société du 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au 1B, rue Heienhaff, L-1736
Senningerberg.
2. Modification subséquente du premier et du deuxième paragraphe de l’article 3 des statuts de la Société afin de leur
donner la teneur suivante:
« Art. 3. Le siège social de la Société est établi dans la commune de Niederanven.
Il pourra être transféré à toute autre adresse dans la même commune par simple décision du conseil d'administration.»
3. Modification des définitions suivantes de l’article 2 des statuts de la Société:
«Investisseur BRB désigne BRB Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée établie et existante sous les
lois du Grand-Duché de Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 143659,»
«Investisseur Evergreen désigne Evergreen Real Estate Partners Europe S.à r.l., une société à responsabilité limitée
établie et existante sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 121655,»
«Feeder désigne NSS Feeder S.A., une société anonyme établie et existante sous les lois du Grand-Duché de Luxem-
bourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 143661,»
«MIV désigne NSS Management Investment Vehicle S.A., une société anonyme établie et existante sous les lois du
Grand-Duché de Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 143658,»
«la Société désigne la présente société, telle que définie à l’article 1,»
«Pelican désigne NSS Pelican S.à r.l., une société à responsabilité limitée établie et existante sous les lois du Grand-
Duché de Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 143793,» et
«Sub Feeder désigne NSS Sub Feeder S.à r.l., une société à responsabilité limitée établie et existante sous les lois du
Grand-Duché de Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 143792,»
4. Révocation de M Alan Dundon, résidant professionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg en tant
qu’administrateur de catégorie B de la Société avec effet immédiat.
5. Nomination de M Paul Bijoux, comptable, né le 18 février 1984 à Liverpool (Grande Bretagne), résidant profes-
sionnellement au 1B, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, en tant que qu’administrateur de catégorie B de la Société
avec effet immédiat, pour une durée de six (6) ans.
IV. L’assemblée, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège social de la Société du 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au 1B,
rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier premier et du deuxième paragraphe de l’article 3 des statuts de la Société afin de leur
donner la teneur suivante:
« Art. 3. Le siège social de la Société est établi dans la commune de Niederanven.
Il pourra être transféré à toute autre adresse dans la même commune par simple décision du conseil d'administration.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier les définitions suivantes de l’article 2 des statuts de la Société:
«Investisseur BRB désigne BRB Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée établie et existante sous les
lois du Grand-Duché de Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 143659,»
«Investisseur Evergreen désigne Evergreen Real Estate Partners Europe S.à r.l., une société à responsabilité limitée
établie et existante sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 121655,»
«Feeder désigne NSS Feeder S.A., une société anonyme établie et existante sous les lois du Grand-Duché de Luxem-
bourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 143661,»
142545
L
U X E M B O U R G
«MIV désigne NSS Management Investment Vehicle S.A., une société anonyme établie et existante sous les lois du
Grand-Duché de Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 143658,»
«la Société désigne la présente société, telle que définie à l’article 1,»
«Pelican désigne NSS Pelican S.à r.l., une société à responsabilité limitée établie et existante sous les lois du Grand-
Duché de Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 143793,» et
«Sub Feeder désigne NSS Sub Feeder S.à r.l., une société à responsabilité limitée établie et existante sous les lois du
Grand-Duché de Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 143792,»
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de révoquer M Alan Dundon, résidant professionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882
Luxembourg en tant qu’administrateur de catégorie B de la Société avec effet immédiat.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide de nominer M Paul Bijoux, comptable, né le 18 février 1984 à Liverpool (Grande Bretagne), résidant
professionnellement au 1B, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, en tant que qu’administrateur de catégorie B de la
Société avec effet immédiat, pour une durée de six (6) ans.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge
à raison des présentes, sont évalués à la somme de mille deux cents Euro (EUR 1.200,-).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête du mandataire des
personnes comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française. A la requête de la même
personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau et au mandataire des personnes comparantes, connus
du notaire par leurs noms et prénoms, états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire, le présent acte.
Signé: Drauth, Dechamp, Martinot, Weinandy en remplacement de GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 22 août 2014. Relation: LAC/2014/39349. Reçu soixante-quinze euros (75,00
€).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène Thill.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Luxembourg, le 28 août 2014.
Référence de publication: 2014135690/221.
(140154019) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2014.
Starry Dance Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 4-6, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 155.792.
<i>Extrait des Résolutions de l'Associé Unique de STARRY DANCE S.à r.l. prises le 1 i>
<i>eri>
<i> Septembre 2014i>
L'unique Associé de Starry Dance S.à r.l. (la "Société"), a décidé comme suit:
- de nommer Property and Finance Corporation S.à r.l., avec siège social au 4-6 Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg,
en qualité de Gérant de la société et ce avec effet au 1
er
septembre 2014.
Le Conseil de gérance se compose comme suit:
Rachel Hafedh
Property and Finance Corporation S.à r.l.
Luxembourg, le 1
er
Septembre 2014.
Signature.
Référence de publication: 2014137472/16.
(140156026) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2014.
142546
L
U X E M B O U R G
Liro S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7610 Larochette, 18, place Bleech.
R.C.S. Luxembourg B 138.066.
Les comptes annuels au 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014137288/9.
(140155960) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2014.
Jerona SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 18.202.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014137248/10.
(140156486) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2014.
Hamilton Holding S.à r.l., Société en Commandite spéciale,
(anc. Hamilton Holding S.C.Sp).
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 189.602.
In the year two thousand and fourteen, on the seventh day of August,
Before Us Maître Henri Hellinckx, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,
Is held
an extraordinary general meeting of the partners of Hamilton Holding S.C.Sp (the “Partners”), a "société en com-
mandite spéciale", having its registered office at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxem-
bourg, in course of registration with the Luxembourg trade and companies register (the “Partnership”), incorporated by
a notarial deed enacted on July 31, 2014, not yet published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
The appearing parties request the notary to act that:
I. The general partner of the Partnership, Sancere Limited, a private limited liability company incorporated under the
laws of Jersey, having its registered office at CTV House La Pouquelaye St Helier Jersey JE2 3TP and registered with the
Jersey Companies Registry under number 112584 (the “General Partner”), duly represented by Mr. Régis Galiotto,
notary’s clerk, with professional address at 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue
of a proxy given under private seal.
II. The limited partner of the Partnership, Chablis 2011 Limited, a private limited liability company incorporated under
the laws of Jersey, having its registered office at CTV House La Pouquelaye St Helier Jersey JE2 3TP and registered with
the Jersey Companies Registry under number 109095 (the “Limited Partner”), duly represented by Mr. Régis Galiotto,
notary’s clerk, with professional address at 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue
of a proxy given under private seal.
The proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with the
minutes.
III. The agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Waiving of notice right;
2. Approval of the conversion of the partnership from an S.C.Sp (société en commandite spéciale) to an S.à r.l. (société
à responsabilité limitée);
3. Approval of the subsequent full restatement of the partnership agreement in order to reflect the conversion of the
Partnership to an S.à r.l., pursuant to resolution 2 above;
4. Approval of the appointment of the members of the board of managers; and
5. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the Partners, the following resolutions have been taken:
142547
L
U X E M B O U R G
<i>First resolutioni>
It is resolved that the Partners waives their right to notice to the extraordinary general meeting, which should have
been sent to them prior to this meeting; the Partners acknowledge being sufficiently informed on the agenda and consider
themselves to be validly convened and therefore agree to deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is
resolved further that all the documentation produced to the meeting has been put at the disposal of the Partners within
a sufficient period of time in order to allow them to examine carefully each document.
<i>Second resolutioni>
It is resolved to transform the corporate form of the Partnership (the “Conversion”) from a société en commandite
spéciale into a société à responsabilité limitée with immediate effect and without discontinuity of its legal personality (the
“Company”).
The Conversion is made on the basis of (i) an interim balance sheet of the Partnership as of July 31, 2014 and (ii) a
statement of value dated August 7, 2014, copies of which have been given to the undersigned notary.
It is further resolved to divide the Partnership capital of EUR 3,265,000 (three million two hundred sixty five thousand
Euros) into 6,530,000 (six millions five hundred thirty thousand) shares of a nominal value of EUR 0.5 (fifty cents Euros),
out of which 7,183 (seven thousand one hundred eighty three) shares will be held by the General Partner and the remaining
6,522,817 (six millions five hundred twenty two thousand eight hundred seventeen) shares will be held by the Limited
Partner.
The Partners acknowledge the end of the General Partner's mandate as manager with effective date as at August 7,
2014 and grant it full discharge for the execution of its mandate.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the foregoing statement and resolution, it is resolved to fully amend and restate the Partnership’s
articles of association to read as follows (the “Articles of Association”):
"Name - Object - Registered office - Duration
Art. 1. There is hereby formed a “société à responsabilité limitée”, limited liability company (the “Company”), governed
by the present Articles and by current Luxembourg laws (the “Law”), in particular the law of 10 August 1915 on com-
mercial companies, as amended (the “Commercial Companies Law”).
Art. 2. The Company’s name is “Hamilton Holding S.à r.l.”.
Art. 3. The Company’s purpose is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial,
industrial, financial or other, Luxembourg or foreign companies or enterprises and to acquire through participations,
contributions, underwriting, purchases or options, negotiation or in any other way any securities, rights, patents and
licences, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage,
develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and in
particular for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in financial,
commercial and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other
company which belong to the same group of companies than the Company any assistance, loans, advances or guarantees;
to borrow and raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed.
The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all
areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.
Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
The registered office may be transferred within the municipality of the City of Luxembourg by decision of the board
of managers or the sole manager (as the case may be).
The registered office of the Company may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg or
abroad by means of a resolution of an extraordinary general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the
case may be) adopted under the conditions required for amendment of the Articles.
The Company may have offices and branches (whether or not a permanent establishment) both in Luxembourg and
abroad.
In the event that the board of managers or the sole manager (as the case may be) should determine that extraordinary
political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstan-
ces; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken
and notified to any interested parties by the board of managers or the sole manager (as the case may be) of the Company.
Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.
142548
L
U X E M B O U R G
Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency
of any shareholder.
Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are not allowed, in any circumstances,
to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the management
of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the
meetings of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be).
Capital - Share
Art. 8. The Company's share capital is set at EUR 3,265,000 (three million two hundred sixty-five thousand Euros),
represented by 6,530,000 (six million five hundred thirty thousand) shares with a nominal value of EUR 0.5 (fifty cents
Euros) each, distributed amongst the types and classes of shares as set out below:
- 653,000 (six hundred fifty three thousand) class A shares, hereafter referred to as the “Class A Shares”;
- 653,000 (six hundred fifty three thousand) class B shares, hereafter referred to as the “Class B Shares”;
- 653,000 (six hundred fifty three thousand) class C shares, hereafter referred to as the “Class C Shares”;
- 653,000 (six hundred fifty three thousand) class D shares, hereafter referred to as the “Class D Shares”;
- 653,000 (six hundred fifty three thousand) class E shares, hereafter referred to as the “Class E Shares”;
- 653,000 (six hundred fifty three thousand) class F shares, hereafter referred to as the “Class F Shares”;
- 653,000 (six hundred fifty three thousand) class G shares, hereafter referred to as the “Class G Shares”;
- 653,000 (six hundred fifty three thousand) class H shares, hereafter referred to as the “Class H Shares”;
- 653,000 (six hundred fifty three thousand) class I shares, hereafter referred to as the “Class I Shares”;
- 653,000 (six hundred fifty three thousand) class J shares, hereafter referred to as the “Class J Shares”.
The amount of the share capital of the Company may be increased or reduced by means of a resolution of the
extraordinary general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) adopted under the con-
ditions required for amendment of the Articles.
Art. 9. Each share confers an identical voting right and each shareholder has voting rights commensurate to his sha-
reholding.
Art. 10. The shares are freely transferable among the shareholders.
Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless shareholders representing at least three-quarter
of the share capital shall have agreed thereto in a general meeting.
Furthermore, the provisions of articles 189 and 190 of the Commercial Companies Law shall apply.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admits only one owner per share.
Art. 11. The Company may redeem its shares under due observance of the provisions of the Commercial companies
Law and these Articles of Association.
Furthermore, subject to compliance with the Law, either the board of managers or the holders of the shares, which
are in issue at a given moment, shall be entitled to request the extraordinary general meeting of shareholders or of the
sole shareholder (as the case may be) to redeem, at a majority adopted under the conditions required for amendment
of the Articles, all or part of their shares by serving them a notice specifying the number of shares to be redeemed and
the date on which the redemption is to take place.
The redemption of a class of shares may only be made according to the following rules:
- All or part of the Class A Shares may be redeemed only at a date posterior to the date of the incorporation of the
Company (the “First Redemption Date”). The redemption price of all or part of the Class A Shares shall comprise the
available distributable profit of the Company over a period starting from the date of the incorporation of the Company
until the First Redemption Date (the “Class A Shares Period”) pro rata to the number of Class A Shares redeemed having
regards to the total number of Class A Shares plus the aggregate par value of all the Class A Shares to be redeemed and
the special reserve attached thereof if any. In case of partial redemption of Class A Shares, the remaining Class A Shares
outstanding shall entitle their holder to the remaining available distributable profit of the Company accrued during the
Class A Shares Period.
- All or part of the Class B Shares may be redeemed only at a date posterior to the date of the First Redemption Date
(the “Second Redemption Date”). The redemption price of all or part of the Class B Shares shall comprise the available
distributable profit of the Company over a period starting from the First Redemption Date until the Second Redemption
Date (the “Class B Shares Period”) pro rata to the number of Class B Shares redeemed having regards to the total number
of Class B Shares plus the aggregate par value of all the Class B Shares to be redeemed and the special reserve attached
thereof if any. In case of partial redemption of Class B Shares, the remaining Class B Shares outstanding shall entitle their
holder to the remaining available distributable profit of the Company accrued during the Class B Shares Period.
- The above rules shall be applicable to other Classes of Shares mutatis mutandis, it being understood that all or part
of a Class of Shares cannot be redeemed before the previous Class of Shares (in alphabetical order) has been fully
redeemed.
142549
L
U X E M B O U R G
The redemption of shares may not result in reducing the net assets of the Company below the aggregate amount of
the subscribed share capital and the reserves that may not be distributed under the Law and these Articles of Association.
The redemption price will be determined on the basis of interim accounts and taking into account available funds and
assets. Therefore, the redemption can only be made by using sums coming from profit, or a fresh issue of shares or from
sums allocated to distributable reserves such as the share premium reserve or from the legal reserve in proportion to
the capital reduction resulting from the cancellation of the shares.
Immediately after the payment of the redemption price, the extraordinary general meeting of shareholders or of the
sole shareholder (as the case may be) shall decrease the share capital by cancelling the redeemed shares.
Management
Art. 12. The Company will be managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers composed of one or several category A manager(s) and one or several category B manager
(s). The manager(s) need not be shareholders of the Company.
The manager(s) shall be appointed and designated as category A manager or category B manager, and his/their remu-
neration determined, by a resolution of the general meeting of shareholders taken by simple majority of the votes cast,
or of the sole shareholder (as the case may be). The remuneration of the manager(s) can be modified by a resolution
taken at the same majority conditions.
The general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) may, at any time and ad nutum,
remove and replace any manager.
All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of shareholders or to the sole
shareholder (as the case may be) fall within the competence of the board of managers, or of the sole manager (as the
case may be).
In dealing with third parties, the manager, or, in case of plurality of managers, the board of managers, will have all
powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company’s object, provided the terms of these Articles shall have been complied with.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by (i)
the sole signature of any manager for any payment not exceeding EUR 10,000 (ten thousand Euros) and (ii) the joint
signature of one category A manager and one category B manager for any payment equal or greater than EUR 10,000
(ten thousand Euros).
The board of managers or the sole manager (as the case may be), may from time to time sub-delegate its/his powers
for specific tasks to one or several ad hoc agent(s) who need not be shareholder(s) or manager(s) of the Company.
The board of managers, or the sole manager (as the case may be) will determine the powers, duties and remuneration
(if any) of its agent(s), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.
Art. 13. In case of plurality of managers, the decisions of the managers are taken by meeting of the board of managers.
The board of managers shall appoint from among its members a chairman which in case of tie vote, shall not have a
casting vote. The chairman shall preside at all meetings of the board of managers. In case of absence of the chairman, the
board of managers shall be chaired by a manager present and appointed for that purpose. It may also appoint a secretary,
who needs not to be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers
or for such other matter as may be specified by the board of managers.
The board of managers shall meet when convened by one manager.
Notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least two 2 days in advance of the
time set for such meeting except in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the minute of the
meeting.
Any convening notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be transacted.
Convening notices can be given to each manager by word of mouth, in writing or by fax, cable, telegram, telex,
electronic means or by any other suitable communication means.
The notice may be waived by the consent, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or by any other
suitable communication means, of each manager.
The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.
No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by a
resolution of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex or electronic
means another manager as his proxy.
A manager may represent more than one manager.
The managers may participate in a board of managers meeting by phone, videoconference, or any other suitable
telecommunication means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time, provided
that a majority of the managers shall never attend the meeting while being located in the same foreign jurisdiction.
Such participation in a meeting is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the managers.
142550
L
U X E M B O U R G
The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented,
including at least one category A manager and one category B manager.
Decisions of the board of managers are adopted by a majority of the managers participating to the meeting or duly
represented thereto provided that at least one category A manager approved these resolutions.
The deliberations of the board of managers shall be recorded in the minutes, which have to be signed by the chairman
or one category A manager and one category B manager. Any transcript of or excerpt from these minutes shall be signed
by the chairman or one category A manager and one category B manager.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at a
managers’ meeting.
In such cases, written resolutions can either be documented in a single document or in several separate documents
having the same content.
Written resolutions may be transmitted by ordinary mail, fax, cable, telegram, telex, electronic means, or any other
suitable telecommunication means.
Art. 14. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly
taken by him in the name of the Company; as a representative of the Company, he is only responsible for the execution
of his mandate.
General meetings of shareholders
Art. 15. In case of plurality of shareholders, decisions of the shareholders are taken as follows:
The holding of a shareholders meeting is not compulsory as long as the shareholders number is less than twenty-five.
In such case, each shareholder shall receive the whole text of each resolution or decision to be taken, transmitted in
writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or any other suitable telecommunication means. Each share-
holder shall vote in writing.
If the shareholders number exceeds twenty-five, the decisions of the shareholders are taken by meetings of the sha-
reholders. In such a case one general meeting shall be held at least annually in Luxembourg within six months of the
closing of the last financial year. Other general meetings of shareholders may be held in the Grand-Duchy of Luxembourg
at any time specified in the notice of the meeting.
Art. 16. General meetings of shareholders are convened and written shareholders resolutions are proposed by the
board of managers, or the sole manager (as the case may be), failing which by shareholders representing more than the
half of the share capital of the Company.
Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be made pursuant to the Law and shall
be sent to each shareholder at least 8 (eight) days before the meeting, except for the annual general meeting for which
the notice shall be sent at least 21 (twenty-one) days prior to the date of the meeting.
All notices must specify the time and place of the meeting.
If all shareholders are present or represented at the general meeting and state that they have been duly informed of
the agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice.
Any shareholder may act at any general meeting by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic
means or by any other suitable telecommunication means another person who needs not be shareholder.
Each shareholder may participate in general meetings of shareholders.
Resolutions at the meetings of shareholders or resolutions proposed in writing to the shareholders are validly taken
in so far as they are adopted by shareholders representing more than the half of the share capital of the Company.
If this quorum is not formed at a first meeting or at the first consultation, the shareholders are immediately convened
or consulted a second time by registered letter and resolutions will be taken at the majority of the vote cast, regardless
of the portion of capital represented.
However, resolutions to amend the Articles shall only be taken by an extraordinary general meeting of shareholders,
at a majority of shareholders representing at least three-quarters of the share capital of the Company.
A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the Law.
Except in case of current operations concluded under normal conditions, contracts concluded between the sole sha-
reholder and the Company have to be recorded in minutes or drawn-up in writing.
Financial year - Balance sheet
Art. 17. The Company's financial year begins on 1 April and closes on 31 March.
Art. 18. Each year, as of 31 March, the board of managers, or the sole manager (as the case may be) will draw up the
balance sheet which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be
accompanied by an annex containing a summary of all its commitments and the debts of the manager(s), statutory auditor
(s) (if any) and shareholder(s) toward the Company.
142551
L
U X E M B O U R G
At the same time the board of managers or the sole manager (as the case may be) will prepare a profit and loss account,
which will be submitted to the general meeting of shareholders together with the balance sheet.
Art. 19. Each shareholder may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.
If the shareholders number exceeds twenty-five, such inspection shall be permitted only during the fifteen days pre-
ceding the annual general meeting of shareholders.
Supervision of the company
Art. 20. If the shareholders number exceeds twenty-five, the supervision of the Company shall be entrusted to one
or more statutory auditor(s) (commissaire), who may or may not be shareholder(s).
Each statutory auditor shall serve for a term ending on the date of the annual general meeting of shareholders following
their appointment dealing with the approval of the annual accounts.
At the end of this period and of each subsequent period, the statutory auditor(s) can be renewed in its/their function
by a new resolution of the general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) until the
holding of the next annual general meeting dealing with the approval of the annual accounts.
Where the thresholds of article 35 of the law of 19 December 2002 on the Luxembourg Trade and Companies Register
are met, the Company shall have its annual accounts audited by one or more qualified auditors (réviseurs d’entreprises)
appointed by the general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) amongst the members of
the “Institut des réviseurs d’entreprises”.
Notwithstanding the thresholds above mentioned, at any time, one or more qualified auditor may be appointed by
resolution of the general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) that shall decide the
terms and conditions of his/their mandate.
Dividend - Reserves
Art. 21. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisations, charges
and provisions represents the net profit of the Company.
Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued share capital,
as decreased or increased from time to time, but shall again become compulsory if the statutory reserve falls below such
one tenth.
The general meeting of shareholders at the majority vote determined by the Law or the sole shareholder (as the case
may be) may decide at any time that the excess be distributed to the shareholder(s) proportionally to the shares they
hold, as dividends or be carried forward or transferred to an extraordinary reserve.
Art. 22. Notwithstanding the provisions of the preceding article, the general meeting of shareholders of the Company,
or the sole shareholder (as the case may be) upon proposal of the board of managers or the sole manager (as the case
may be), may decide to pay interim dividends before the end of the current financial year, on the basis of a statement of
accounts prepared by the board of managers or the sole manager (as the case may be), and showing that sufficient funds
are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since
the end of the last financial year, increased by profits carried forward and available reserves, less losses carried forward
and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or the Articles.
Winding-up - Liquidation
Art. 23. The general meeting of shareholders under the conditions required for amendment of the Articles, or the
sole shareholder (as the case may be) may resolve the dissolution of the Company.
Art. 24. The general meeting of shareholders with the consent of at least half of the shareholders holding three quarters
of the share capital shall appoint one or more liquidator(s), physical or legal person(s) and determine the method of
liquidation, the powers of the liquidator(s) and their remuneration.
When the liquidation of the Company is closed, the liquidation proceeds of the Company will be allocated to the
shareholders proportionally to the shares they hold.
Applicable law
Art. 25. Reference is made to the provisions of the Law for which no specific provision is made in these Articles.”
<i>Transitory provisioni>
The first accounting year of the Company shall begin on the date of the formation of the Company and end on March
31
th
, 2015.
<i>Fourth resolutioni>
Further to the Conversion, it is resolved to appoint for an unlimited duration the following persons as managers of
the Company which will be the following:
142552
L
U X E M B O U R G
- Jan Peter Olszowski, born on January 16, 1962 in London, United Kingdom, with professional address at Wierzbowa
10, 81 - 558 Gdynia, Poland, as category A Manager; and
- Intertrust Management (Luxembourg) S.à r.l., a private limited liability company («société à responsabilité limitée»),
having its registered office at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg and registered
with the Luxembourg trade and companies register under number B 103336, as category B Manager.
<i>Costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with this deed have been estimated at about three thousand four hundred Euros (3,400.-
EUR).
<i>Declarationi>
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original
deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Traduction française du texte qui précède
L’an deux mil quatorze, le sept août.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire demeurant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
Est tenue
une assemblée générale extraordinaire des associés de Hamilton Holding S.C.Sp (les «Associés»), une société en
commandite spéciale, ayant son siège social sis à 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg, en cours d’immatriculation auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg (la «S.C.Sp»),
constituée par un acte notarié reçu le 31 juillet 2014, en attente de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations.
Les comparantes demande au notaire d’acter que:
I. L’associé commandité de la S.C.Sp, Sancere Limited, une société à responsabilité limitée constituée sous les lois de
Jersey, ayant son siège social à CTV House La Pouquelaye St Helier Jersey JE2 3TP et immatriculée auprès du registre
des sociétés de Jersey sous le numéro 112584 (l’«Associé Commandité»), ici représenté par Monsieur Régis Galiotto,
clerc de notaire, avec adresse professionnelle au 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en
vertu d’une procuration donnée sous seing privé.
II. L’associé commanditaire de la S.C.Sp, Chablis 2011 Limited, une société à responsabilité limitée constituée sous les
lois de Jersey, ayant son siège social à CTV House La Pouquelaye St Helier Jersey JE2 3TP et immatriculée auprès du
registre des sociétés de Jersey sous le numéro 109095 (l’«Associé Commanditaire»), ici représenté par Monsieur Régis
Galiotto, clerc de notaire, avec adresse professionnelle au 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg, Grand-Duché de Lu-
xembourg, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé.
Les procurations, signées par les comparantes et le notaire instrumentant, demeureront annexées au présent acte
pour être soumises avec lui aux formalités d’enregistrement.
III. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1- Renonciation au droit de convocation;
2- Approbation de la transformation de la société en commandite d’une S.C.Sp (société en commandite spéciale) en
S.à r.l. (société à responsabilité liimitée);
3- Approbation de la refonte complète subséquente des statuts afin de refléter la conversion de la société en com-
mandite en S.à r.l., suite à la résolution 2 ci-dessus;
4- Approbation de la nomination des membres du conseil de gérance; et
5- Divers.
Après l’approbation par les Associés de ce qui précède, les résolutions suivantes ont été prises.
<i>Première résolutioni>
Les Associés décident de renoncer à leur droit de convocation à une assemblée générale extraordinaire, en vertu
duquel une convocation aurait dû leur être adressée avant la tenue de cette assemblée générale; les Associés reconnaissent
être suffisamment informés sur cet ordre du jour et considèrent qu’ils ont été valablement convoqués et par conséquent
acceptent de délibérer et voter sur tous les sujets figurant à l’ordre du jour. Il est aussi décidé que tous les documents
142553
L
U X E M B O U R G
produits au cours de l’assemblée ont été mis à la disposition des Associés pendant une période suffisante afin de leur
permettre d’en prendre soigneusement connaissance.
<i>Seconde résolutioni>
Il est décidé de transformer la forme sociale de la S.C.Sp (la «Transformation») d’une société en commandite spéciale
en société à responsabilité limitée avec effet immédiat et sans perte de sa personnalité morale (la «Société»).
La Transformation est effectuée sur la base de (i) comptes intérimaires de la S.C.Sp au 31 juillet 2014 et (ii) d’une
déclaration de valeur datée du 7 août 2014, copies desquels, ont été donnés au notaire soussigné.
Il est également décidé de diviser le capital social de la S.C.Sp de 3.265.000 EUR (trois millions deux cent soixante-
cinq mille Euros) en 6.530.000 (six millions cinq cent trente mille) parts sociales d’une valeur nominale de 0,5 EUR
(cinquante centimes d’euros), parmi lesquelles 7.183 (sept mille cent quatre-vingt-trois) parts sociales seront détenues
par l’Associé Commandité et les 6.522.817 (six millions cinq cent vingt-deux mille huit cent dix-sept) parts sociales
restantes seront détenues par l’Associé Commanditaire.
Les Associés prennent acte de la fin du mandat de l’Associé Commandité en tant que gérant avec date d’effet au 7
août 2014 et lui donnent décharge pour l’exécution de son mandat.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence de la résolution précédente, il est décidé de modifier entièrement et refondre les statuts de la S.C.Sp
comme suit (les «Statuts»):
«Dénomination - Objet - Siège - Durée.
Art. 1
er
. Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée (la «Société»), régie par les présents Statuts
et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur (la «Loi»), notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée (la «Loi sur les Sociétés Commerciales»).
Art. 2. La dénomination de la Société sera «Hamilton Holding S.à r.l.».
Art. 3. L'objet de la Société est de prendre des participations et intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans toutes
sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, d'acquérir
par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre
manière tous titres, droits, valeurs, brevets et licences et autres droits réels, droits personnels et intérêts, comme la
Société le jugera utile, et de manière générale de les détenir, les gérer, les mettre en valeur et les céder en tout ou en
partie, pour le prix que la Société jugera adapté et en particulier contre les parts ou titres de toute société les acquérant;
de conclure, d'assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou autres et d'octroyer à toute
société holding, filiale ou toute autre société liée d’une manière ou d’une autre à la Société ou toute société appartenant
au même groupe de sociétés, tout concours, prêts, avances ou garanties; d'emprunter ou de lever des fonds de quelque
manière que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée.
La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte
avec les secteurs pré décrits et aux fins de faciliter l’accomplissement de son objet.
Art. 4. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Le siège social pourra être transféré dans la commune de la ville de Luxembourg par décision du conseil de gérance
ou du gérant unique (selon le cas).
Le siège social de la Société pourra être transféré en tout autre lieu au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger
par décision de l’assemblée générale extraordinaire des associés ou de l’associé unique (selon le cas) adoptée selon les
conditions requises pour la modification des Statuts.
La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales (sous forme d’établissement permanent ou non) tant au Grand-
Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) estimerait que des événements extraordinaires
d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’activité normale de la Société à son siège social ou
la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer
provisoirement le siège social à l’étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure
provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège
restera luxembourgeoise. Pareille mesure provisoire sera prise et portée à la connaissance des tiers par le conseil de
gérance ou le gérant unique (selon le cas) de la Société.
Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 6. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société.
Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront, pour quelque motif que ce
soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les
142554
L
U X E M B O U R G
actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées ou de l’associé unique (selon le cas).
Capital - Parts sociales
Art. 8. Le capital social est fixé à 3.265.000 EUR (trois millions deux cent soixante-cinq mille euros) représenté par
6.530.000 (six millions cinq cent trente mille) parts sociales d’une valeur nominale de 0,5 EUR (cinquante centimes d’euros)
chacune, distribué parmi les types et classes de parts sociales suivants:
- 653.000 (six cent cinquante-trois mille) parts sociales de classe A, ci-après les «Parts Sociales de Classe A»;
- 653.000 (six cent cinquante-trois mille) parts sociales de classe B, ci-après les «Parts Sociales de Classe B»;
- 653.000 (six cent cinquante-trois mille) parts sociales de classe C, ci-après les «Parts Sociales de Classe C»;
- 653.000 (six cent cinquante-trois mille) parts sociales de classe D, ci-après les «Parts Sociales de Classe D»;
- 653.000 (six cent cinquante-trois mille) parts sociales de classe E, ci-après les «Parts Sociales de Classe E»;
- 653.000 (six cent cinquante-trois mille) parts sociales de classe F, ci-après les «Parts Sociales de Classe F»;
- 653.000 (six cent cinquante-trois mille) parts sociales de classe G, ci-après les «Parts Sociales de Classe G»;
- 653.000 (six cent cinquante-trois mille) parts sociales de classe H, ci-après les «Parts Sociales de Classe H»;
- 653.000 (six cent cinquante-trois mille) parts sociales de classe I, ci-après les «Parts Sociales de Classe I»;
- 653.000 (six cent cinquante-trois mille) parts sociales de classe J, ci-après les «Parts Sociales de Classe J».
Le montant du capital de la Société peut être augmenté ou réduit au moyen d’une résolution de l’assemblée générale
extraordinaire des associés ou de l’associé unique (selon le cas) prise dans les formes requises pour la modification des
Statuts.
Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions et chaque associé a un
nombre de droit de vote proportionnel aux nombres de parts qu’il détient.
Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée sans l’agrément donné en
assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi sur les Sociétés Commerciales.
Les parts sont indivisibles à l’égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle.
Art. 11. La Société peut racheter ses parts sociales à condition d’observer les dispositions de la Loi sur les Sociétés
Commerciales ainsi que les présents Statuts.
De plus, sous réserve du respect de la Loi, soit le conseil de gérance, soit les détenteurs des parts sociales, qui font
l’objet d’une émission à un moment donné, pourront demander la tenue d’une assemblée générale des associés or de
l’associé unique (selon le cas) pour racheter, dans les conditions de majorité requises pour la modification des Statuts,
tout ou partie de leurs parts sociales en leur adressant une notification détaillant le nombre de parts sociales à racheter
et la date à laquelle le rachat doit se produire.
Le rachat d’une classe de part sociale doit respecter les règles ci-dessous:
- Toutes ou partie des Parts Sociales de Classe A ne peuvent faire l’objet d’un rachat qu’après la date de constitution
de la Société (la «Première Date de Rachat»). Le prix de rachat de toutes ou partie des Parts Sociales de Classe A doit
comprendre le profit distribuable disponible de la Société sur une période commençant à partir de la date de constitution
de la Société jusqu’à la Première Date de Rachat (la «Période des Parts Sociales de Classe A») au pro rata du nombre
Parts Sociales de Classe A rachetées au regard du nombre total des Parts Sociales de Classe A plus la valeur nominale
globale de toutes les Parts Sociales de Classe A devant être rachetées ainsi que la réserve spéciale qui lui est attachée, le
cas échéant. En cas de rachat partiel des Parts Sociales de Classe A, les Parts Sociales de Classe A restantes ouvriront le
droit à leur détenteur au reste du profit distribuable disponible de la Société qui a produit des intérêts pendant la Période
des Parts Sociales de Classe A.
- Toutes ou partie des Parts Sociales de Classe B ne peuvent faire l’objet d’un rachat qu’après la Première Date de
Rachat (la «Seconde Date de Rachat»). Le prix de rachat de toutes ou partie des Parts Sociales de Classe B doit com-
prendre le profit distribuable disponible de la Société sur une période commençant à partir de la Première Date de Rachat
jusqu’à la Seconde Date de Rachat (la «Période des Parts Sociales de Classe B») au pro rata du nombre Parts Sociales de
Classe B rachetées au regard du nombre total des Parts Sociales de Classe B plus la valeur nominale globale de toutes
les Parts Sociales de Classe B devant être rachetées ainsi que la réserve spéciale qui lui est attachée, le cas échéant. En
cas de rachat partiel des Parts Sociales de Classe B, les Parts Sociales de Classe B restantes ouvriront le droit à leur
détenteur au reste du profit distribuable disponible de la Société qui a produit des intérêts pendant la Période des Parts
Sociales de Classe B.
- Les règles décrites ci-dessus sont applicables mutatis mutandis aux autres Classes de Parts Sociales, étant compris
que toutes ou partie des Classes de Parts Sociales ne peuvent pas être rachetées avant la précédente Classe de Parts
Sociales (par ordre alphabétique) ait été entièrement rachetée.
142555
L
U X E M B O U R G
Le rachat de parts sociales n’aura pas pour conséquence la réduction des actifs nets de la Société en dessous du montant
global du capital social souscrit ainsi que les réserves qui ne peuvent pas être distribuées en raison de la Loi ou des présents
Statuts. Le prix de rachat sera déterminé sur la base de comptes intérimaires et par la prise en compte des fonds dispo-
nibles et des actifs. Par conséquent, le rachat ne peut être effectué qu’en utilisant des sommes provenant d’un profit, ou
d’une émission récente de parts sociales ou de sommes allouées aux réserves distribuables telles que la réserve de prime
d’émission ou de la réserve légale à proportion de la réduction de capital résultant d’une annulation de parts sociales.
Immédiatement après le paiement du prix de rachat, l’assemblée générale extraordinaire des associés ou de l’associé
unique (selon les cas) devra décider de la réduction du capital social par l’annulation des parts sociales rachetées.
Gérance
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil
de gérance composé d’un ou plusieurs gérant(s) de catégorie A et d’un ou plusieurs gérant(s) de catégorie B. Le(s) gérant
(s) ne sont pas obligatoirement associés de la Société.
Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) et désigné(s) en qualité de gérant de catégorie A ou en qualité de gérant de catégorie
B et sa/leur rémunération est fixée par résolution de l’assemblée générale des associés prise à la majorité simple des voix
exprimées ou par décision de l’associé unique (selon le cas). La rémunération du/des gérant(s) peut être modifiée par
résolution prise dans les mêmes conditions de majorité.
Le(s) gérants peut/peuvent être révoqués à tout moment, par une résolution de l’assemblée générale des associés ou
par une décision de l’associé unique (selon le cas).
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés ou l’associé unique (selon le cas)
par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du conseil de gérance ou du gérant unique (selon le cas).
Vis-à-vis des tiers, le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, aura tous pouvoirs pour
agir en toutes circonstances au nom de la Société et de réaliser et approuver tous actes et opérations en relation avec
l’objet social dans la mesure où les termes de ces Statuts auront été respectés.
La Société sera engagée par la seule signature de son gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par (i) la seule
signature de tout gérant pour tout paiement n’excédant pas 10.000 EUR (dix mille euros) et (ii) la signature conjointe
d’un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B pour tout paiement égal ou supérieur à 10.000 EUR (dix mille
euros).
Le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) peut, de temps en temps, subdéléguer une partie de ses pouvoirs
pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc qui ne sont pas nécessairement associés ou gérants de la
Société.
Le conseil de gérance ou le seul gérant (selon le cas) détermine les responsabilités et la rémunération (s’il y a lieu) de
ces agents, la durée de leur mandat ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
Art. 13. En cas de pluralité de gérants, les décisions des gérants sont prises en réunion du conseil de gérance.
Le conseil de gérance désignera parmi ses membres un président qui en cas d’égalité de voix, n’aura pas de voix
prépondérante. Le président pourra présider toutes les assemblées du conseil de gérance. En cas d’absence du président,
le conseil de gérance pourra être présidé par un gérant présent et nommé à cette occasion. Il peut également choisir un
secrétaire, lequel n’est pas nécessairement gérant, qui sera responsable de la conservation des procès-verbaux des réu-
nions du conseil de gérance ou de l’exécution de toute autre tâche spécifiée par le conseil de gérance.
Le conseil de gérance se réunira suite à la convocation faite par un gérant.
Pour chaque conseil de gérance, des convocations devront être établies et envoyées à chaque gérant au moins 2 jours
avant la réunion sauf en cas d’urgence, la nature de cette urgence devant être déterminée dans le procès-verbal de la
réunion du conseil de gérance.
Toutes les convocations devront spécifier l’heure et le lieu de la réunion et la nature des activités à entreprendre.
Les convocations peuvent être faites aux gérants oralement, par écrit ou par téléfax, câble, télégramme, télex, moyens
électroniques ou par tout autre moyen de communication approprié.
Chaque gérant peut renoncer à cette convocation par écrit ou par téléfax, câble, télégramme, télex, moyens électro-
niques ou par tout autre moyen de communication approprié.
Les réunions du conseil de gérance se tiendront valablement sans convocation si tous les gérants sont présents ou
représentés.
Une convocation séparée n’est pas requise pour les réunions du conseil de gérance tenues à l’heure et au lieu précisé
précédemment lors d’une résolution du conseil de gérance.
Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par téléfax, câble,
télégramme, télex ou moyens électroniques un autre gérant pour le représenter.
Un gérant peut représenter plusieurs autres gérants.
Les gérants du conseil de gérance peuvent assister à une réunion du conseil de gérance par téléphone, vidéoconférence
ou par tout autre moyen de communication approprié permettant à l’ensemble des personnes présentes lors de cette
142556
L
U X E M B O U R G
réunion de communiquer à un même moment, à condition qu’à aucun moment une majorité des gérants participant à la
réunion ne soit localisée dans le même pays étranger.
Une telle participation à une réunion du conseil de gérance est réputée équivalente à une présence physique à la
réunion.
Le conseil de gérance peut valablement délibérer et agir seulement si une majorité des gérants est présente ou re-
présentée, ce qui comprend au moins un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B.
Les décisions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés, pourvu
qu’au moins un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B approuvent ces résolutions.
Les délibérations du conseil de gérance sont transcrites par un procès-verbal, qui est signé par le président ou par un
gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B. Tout extrait ou copie de ce procès-verbal devra être signé par le
président ou par un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B.
Les résolutions écrites approuvées et signées par tous les gérants auront le même effet que les résolutions prises en
conseil de gérance.
Dans un tel cas, les résolutions peuvent soit être documentées dans un seul document ou dans plusieurs documents
ayant le même contenu.
Les résolutions écrites peuvent être transmises par lettre ordinaire téléfax, câble, télégramme, moyens électroniques
ou tout autre moyen de communication approprié.
Art. 14. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements
régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n'est responsable que de l’exécution de son mandat.
Assemblée générale des associés
Art. 15. En cas de pluralité d’associés, les décisions des associés sont prises comme suit:
La tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-cinq. Dans
ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, transmis par écrit ou par
téléfax, câble, télégramme, télex, moyens électroniques ou tout autre moyen de communication approprié. Chaque as-
socié émettra son vote par écrit.
Si le nombre des associés excède vingt-cinq, les décisions des associés sont prises en assemblée générale des associés.
Dans ce cas une assemblée générale annuelle est tenue à Luxembourg dans les six mois de la clôture du dernier exercice
social. Toute autre assemblée générale des associés se tient au Grand-Duché de Luxembourg à l’heure et au jour fixé
dans la convocation à l’assemblée.
Art. 16. Les assemblées générales des associés sont convoquées et des résolutions écrites des associés sont proposées
par le conseil de gérance ou par le gérant unique (selon le cas) ou, à défaut, par des associés représentant plus de la moitié
du capital social de la Société.
Une convocation écrite à une assemblée générale indiquant l’ordre du jour est faite conformément à la Loi et est
adressée à chaque associé au moins 8 (huit) jours avant l’assemblée, sauf pour l’assemblée générale annuelle pour laquelle
la convocation sera envoyée au moins 21 (vingt et un) jours avant la date de l’assemblée.
Toutes les convocations doivent mentionner la date et le lieu de l’assemblée générale.
Si tous les associés sont présents ou représentés à l’assemblée générale et indiquent avoir été dûment informés de
l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.
Tout associé peut se faire représenter à toute assemblée générale en désignant par écrit ou par téléfax, câble, télé-
gramme, télex, moyens électroniques ou tout autre moyen de télécommunication approprié un tiers qui peut ne pas être
associé.
Chaque associé a le droit de participer aux assemblées générales des associés.
Les résolutions des assemblées des associés ou les résolutions proposées par écrit aux associés ne sont valablement
adoptées que pour autant qu'elles soient prises par les associés représentant plus de la moitié du capital social de la
Société.
Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée générale ou de la première consultation, les associés sont
immédiatement convoqués ou consultés une seconde fois par lettre recommandée et les résolutions seront adoptées à
la majorité des votes exprimés quelle que soit la portion du capital représentée.
Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des Statuts ne pourront être prises qu’en assemblée générale
extraordinaire des associés, à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.
Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la Loi.
Excepté en cas d’opérations courantes conclues dans des conditions normales, les contrats conclus entre l’associé
unique et la Société doivent être inscrits dans un procès verbal ou établis par écrit.
Exercice social - Bilan
Art. 17. L'exercice social commence le 1
er
avril et se termine le 31 mars.
142557
L
U X E M B O U R G
Art. 18. Chaque année, à partir du 31 mars, le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) établira le bilan
qui contiendra l’inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes avec une annexe contenant le résumé de tous
ses engagements, ainsi que les dettes des gérants, des commissaires (s’il en existe) et des associés envers la Société.
Dans le même temps, le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) préparera un compte de profits et pertes
qui sera soumis à l’assemblée générale des associés avec le bilan.
Art. 19. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire, du bilan et du compte
de profits et pertes.
Si le nombre des associés excède vingt-cinq, une telle communication ne sera autorisée que pendant les quinze jours
précédant l’assemblée générale annuelle des associés.
Surveillance de la société
Art. 20. Si le nombre des associés excède vingt-cinq, la surveillance de la Société sera confiée à un ou plusieurs
commissaire(s) aux comptes, associé(s) ou non.
Chaque commissaire sera nommé pour une période expirant à la date de la prochaine assemblée générale annuelle
des associés suivant leur nomination relative à l’approbation des comptes annuels.
A l’expiration de cette période et de chaque période subséquente, le(s) commissaire(s) pourra/pourront être renou-
velé(s) dans ses/leurs fonction(s) par une nouvelle décision de l’assemblée générale des associés ou de l’associé unique
(selon le cas) jusqu'à la tenue de l’assemblée générale annuelle suivante relative à l’approbation des comptes annuels.
Lorsque les seuils de l’article 35 de la loi du 19 Décembre 2002 relative au Registre du Commerce et des Société
luxembourgeois seront atteints, la Société confiera le contrôle de ses comptes à un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises
désigné(s) par résolution de l’assemblée générale des associés ou par l’associé unique (selon le cas) parmi les membres
de l’Institut des réviseurs d’entreprises.
Nonobstant les seuils ci-dessus mentionnés, à tout moment, un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises peuvent être
nommés par résolution de l’assemblée générale des associés ou de l’associé unique (selon le cas) qui décide des termes
et conditions de son/leurs mandat(s).
Dividendes - Réserves
Art. 21. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et
provisions, constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social tel
qu’augmenté ou réduit le cas échéant, mais devront être repris si la réserve légale est inférieure à ce seuil de 10 %.
Les associés, à la majorité prévue par la Loi ou l’associé unique (selon le cas) peuvent décider à tout moment qu'après
déduction de la réserve légale, le bénéfice sera distribué entre les associés au titre de dividendes au prorata de leur
participation dans le capital de la Société ou reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.
Art. 22. Nonobstant les dispositions de l’article précédent, l’assemblée générale des associés de la Société ou l’associé
unique (selon le cas) peut, sur proposition du conseil de gérance ou du gérant unique (selon le cas), décider de payer des
acomptes sur dividendes en cours d'exercice social sur base d'un état comptable préparé par le conseil de gérance ou le
gérant unique (selon le cas), desquels il devra ressortir que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant
entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice
social augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes
à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.
Dissolution - Liquidation
Art. 23. L'assemblée générale des associés, statuant sous les conditions requises pour la modification des statuts
peuvent décider la dissolution anticipée de la Société.
Art. 24. L'assemblée générale des associés avec l’approbation d’au moins la moitié des associés représentant les trois
quarts du capital social, devra nommer un ou plusieurs liquidateur(s) personne(s) physique ou morale et déterminer les
mesures de liquidation, les pouvoirs des liquidateurs ainsi que leur rémunération.
La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au prorata de leur participation dans le
capital de la Société.
Loi applicable
Art. 25. Il est renvoyé aux dispositions de la Loi pour l’ensemble des points au regard desquels les présents Statuts ne
contiennent aucune disposition spécifique.
<i>Dispositions transitoiresi>
Exceptionnellement le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la Société pour finir le 31
mars 2015.
142558
L
U X E M B O U R G
<i>Quatrième résolutioni>
Immédiatement après la Transformation, il est décidé de nommer pour une durée illimitée les personnes suivantes en
tant que gérants de la Société:
- Jan Peter Olszowski, né le 16 janvier 1962 à Londres, Royaume-Uni, dont l’adresse professionnelle est sis à Wierzbowa
10, 81 - 558 Gdynia, Pologne, en qualité de Gérant de catégorie A.
- Intertrust Management (Luxembourg) S.à r.l., une société à responsabilité limitée, dont le siège sociale est sis à 6,
rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 103336, en qualité de Gérant de catégorie B.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, s'élève à environ trois mille quatre cents Euros (3.400.- EUR).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires, ils ont signé avec nous notaire le présent acte.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par le présent acte qu'à la requête des personnes com-
parantes le présent acte est rédigé en anglais suivis d'une version française. A la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 14 août 2014. Relation: LAC/2014/38511. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 27 août 2014.
Référence de publication: 2014135547/659.
(140153772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2014.
Karl 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Ecosse Acquico S.à r.l.).
Siège social: L-2340 Luxembourg, 20, rue Philippe II.
R.C.S. Luxembourg B 188.225.
In the year two thousand and fourteen, on the seventh day of August,
Before the undersigned, Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg,
THERE APPEARED
Nordic Coinvest S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its
registered office at 20, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and not yet being registered
with the Luxembourg Register of Commerce and Companies, here represented by Henri DA CRUZ, employee, residing
professionally in Junglinster, by virtue of a proxy given on 6 August 2014;
Such appearing party is the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of Ecosse Acquico S.à r.l. (hereinafter the "Com-
pany"), a Luxembourg société à responsabilité limitée, having its registered office at 20, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number
B 188.225, incorporated by a notarial deed drawn up by Me Jean Seckler, notary residing in Junglinster, on 18 June 2014.
The articles of incorporation of the Company (the "Articles") have not yet been published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations. The Articles have not been amended since the incorporation of the Company.
The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The appearing party representing the whole corporate capital of the Company requires the notary to act the following
resolution:
<i>Sole resolutioni>
The Sole Shareholder decides to change the corporate name of the Company from "Ecosse Acquico S.à r.l." to "Karl
3 S.à r.l." and to amend article 1 of the Articles which shall henceforth read as follows:
" 1. Corporate form and name. This document constitutes the articles of incorporation (the "Articles") of Karl 3 S.à
r.l. (the "Company"), a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of
the Grand Duchy of Luxembourg including the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended from time
to time (the "1915 Law")."
142559
L
U X E M B O U R G
<i>Costs and expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it
by reason of the present deed are assessed to nine hundred fifty Euro (EUR 950.-).
Whereof the present deed is drawn up in Junglinster, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English, followed by a German version; on request of the appearing parties and in case of divergences between the English
and the German text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties known to the notary by his name, first
name, civil status and residence, the proxyholder of the appearing parties signed together with the notary the present
deed.
Es Folgt die Deutsche Übersetzung:
Im Jahre zweitausendundvierzehn, am siebten Tag des Monats August,
Vor Uns, dem unterzeichnenden Notar Jean SECKLER, Notar, mit Amtssitz in Junglinster, Großherzogtum Luxemburg,
IST ERSCHIENEN
Nordic Coinvest S.à r.l., eine luxemburgische Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Gesellschaftssitz in 20, rue
Philippe II, L-2340 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg und noch nicht im luxemburgischen Handels- und Gesell-
schaftsregister eingetragen,
hier vertreten durch Herrn Henri DA CRUZ, Privatbeamter, geschäftsansässig in Junglinster, aufgrund einer Vollmacht,
die am 6. August 2014 erteilt wurde;
Der Erschienene ist der alleinige Gesellschafter (der "Alleinige Gesellschafter") von "Ecosse Acquico S.à r.l." (im Fol-
genden, die "Gesellschaft"), eine luxemburgische Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Gesellschaftssitz in 20, rue
Philippe II, L-2340 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg und eingetragen im luxemburgischen Handelsund Gesell-
schaftsregister unter der Nummer B 188.225, gegründet durch eine notarielle Urkunde, welche von dem Notar Jean
Seckler, Notar, mit Amtssitz in Junglinster, am 18. Juni 2014 erstellt wurde. Die Satzung der Gesellschaft (die "Satzung")
wurde noch nicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht. Die Satzung wurde seit der Grün-
dung der Gesellschaft nicht abgeändert.
Die genannte Vollmacht, nach "ne varietur" Paraphierung durch den Bevollmächtigten des Erschienenen und den am-
tierenden Notar, bleibt der gegenwärtigen Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.
Der Erschienene, welcher das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, ersucht den Notar den folgenden Beschluss zu
beurkunden:
<i>Einziger Beschlussi>
Der Alleinige Gesellschafter beschließt den Namen der Gesellschaft von "Ecosse Acquico S.à r.l." in "Karl 3 S.à r.l."
und den ersten Artikel der Satzung zu ändern, welcher nunmehr folgenden Wortlaut erhält:
" 1. Rechtsform und Name der Gesellschaft. Die Gesellschaft besteht in der Rechtsform einer Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung (société à responsabilité limitée) unter dem Namen "Karl 3 S.à r.l." (im Folgenden die "Gesellschaft").
Die Gesellschaft unterliegt insbesondere dem Luxemburger Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in
der jeweils gültigen Fassung (im Folgenden das "Gesetz von 1915") und den Vorschriften dieser Satzung (im Folgenden
die "Satzung")."
<i>Kosten und Ausgabeni>
Jegliche Kosten, Ausgaben, Vergütungen oder Abgaben in jeglicher Art, die die Gesellschaft aufgrund dieser notariellen
Urkunde zu tragen hat, werden auf neun hundert fünfzig Euro (EUR 950,-) geschätzt.
Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache spricht und versteht, stellt hiermit fest, dass die vorliegende
Urkunde in englischer Sprache abgefasst wurde, gefolgt von einer deutschen Version; auf Wunsch der erschienenen
Person soll bei Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, die englische Version maßgebend sein.
Worüber die notarielle Urkunde in Junglinster aufgenommen wurde.
An dem Tag und zu der Zeit, der bzw. die zu Beginn dieses Dokuments genannt ist.
Nachdem das Dokument der erschienenen Person vorgelesen wurde, die dem Notar mit ihrem Nachnamen, Vorn-
amen, Personenstand und Wohnsitz bekannt sind, hat diese erschienene Personen gemeinsam mit dem Notar die
vorliegende Urkunde gezeichnet.
Gezeichnet: Henri DA CRUZ, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 13 août 2014. Relation GRE/2014/3257. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2014136089/84.
(140154591) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2014.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
142560
Abrego Lux S.A.
Actisat S.A.
Actistore S.A.
Actistore S.A.
Aforcomlux SA
Amber Properties S.à r.l.
Arista SA SICAV-SIF
Bejimac S.A.
Bewa-Invest Sàrl
Bourdon Holdings S.A.
b-to-v Partners S.à r.l.
Cap Decision
Cap Vinci
CD Private Equity Sicar S.à r.l.
Centuria Capital Développement Durable S. à r.l. (C2D2)
CIPEF VI QGOG S.à r.l.
ColEssen S.à.r.l.
COMMUNICATION, SALES AND MARKETING CONSULT (CSM Consult) S.à r.l.
Compagnie Européenne de Promotion (C.E.P.) S.A., SPF
Crêperie Bretonne
CSC Computer Sciences Holdings S.à r.l.
CTS Soparfi S.A.
Culligan Holding S.à r.l.
Darena Invest S.à r.l.
Ecosse Acquico S.à r.l.
Geoenergy S.A.
Gestion d'Assurances S.A.
Hamilton Holding S.à r.l.
Hamilton Holding S.C.Sp
Havel Holding S.à r.l.
Home & Garden S.A.
Imso Lux S.A.
Jerona SPF S.A.
JPF Distribution S.à r.l.
Karl 3 S.à r.l.
Lefèvre-Evrard
Liro S.A.
Lockdale Sports s.à r.l.
Mafic S.A.
Neroli
Nextech IV GP S.à r.l.
NSS New Luxco S.A.
Olivia S.A.
Omicron Asset Management S.à r.l.
Onyxs Sàrl
Pearl Management S.A.
Promanté S.A.
Pro-Toitures Gestion S.à r.l.
Pro-Toitures S.A.
PS1 Luxco S.à r.l.
Starry Dance Sàrl
Triton Luxembourg GP Compo S.C.A.
Tuilia Invest S.A.
Valentin Capital Management S.A.
Veramont Immeubles S.A.
Victoria Capital Holdings S.A.
YGIP-ASIA PAC S.à r.l.
YG IP S.à r.l.
YG S.à r.l.
Zabar Group Holding Sàrl
Zephyros Property S.A.
Zeus Group Lux S.à r.l.