logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2947

15 octobre 2014

SOMMAIRE

20140726 Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

141436

FVD House S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141423

GC Extreme S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141420

Kara Finance SPF S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141410

Karel S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141435

Keasy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141410

Keasy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141410

Knauf Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

141410

Koromandel Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

141410

Krabi International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

141410

Lapi Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141416

LDV Management II Meigerhorn II S.C.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141417

Likipi Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141415

Lodging Products & Services S.à r.l.  . . . . .

141416

LOGOS IT Services S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

141415

Madinina S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141417

Mail Order World S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

141411

Maisons du Monde Luxembourg, S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141411

Malva S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141415

Mavilla Immobilière S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

141419

MBNA R&L S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141416

Mc. Innovation S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141416

Midas Holdco IV S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

141413

Muller & Associés S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141418

Naturfleesch S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141419

New Blitz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141417

New Energy Above Training  . . . . . . . . . . . .

141417

Octopus Development S.A.  . . . . . . . . . . . . .

141419

Open V-IT Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141418

Pegasus Holdings (Belgium) S.à r.l.  . . . . . .

141420

Pine River Fixed Income Lux Investments

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141414

Platinum UCITS Funds SICAV  . . . . . . . . . .

141418

Praxair Holding Latinoamérica  . . . . . . . . . .

141419

Re Schools S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141414

Roda S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141416

RSM Cosal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141421

Satofi S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141413

Sephir Participation S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

141412

SG Audit S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141411

Silver Star S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141411

Simius Promotions S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

141412

Société Financière du Méditerranéen S.A.,

SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141412

Société Financière du Méditerranéen S.A.,

SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141412

Sonnenhof S.A. SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141411

Soparfi Codes Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . .

141426

St Charles Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . .

141414

Stonegate Pub Company Group S.à r.l.  . .

141412

Swedbank Management Company S.A.  . .

141413

TCW/MAC Capital Ltd. Luxembourg S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141421

Timea Properties S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

141430

Timone GP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141421

Toiture Moderne N.E. Sàrl  . . . . . . . . . . . . . .

141413

TradeRisks (Luxembourg) S.à r.l.  . . . . . . . .

141447

TRALUX, Société Générale de Travaux -

Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141420

UrbaniaBT1 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141422

VH In Solutions S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141423

VLW Lion S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141421

YGIP-ASIA PAC S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

141456

141409

L

U X E M B O U R G

Kara Finance SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 48.745.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014133188/9.
(140151027) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2014.

Keasy, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8080 Bertrange, 2, rue Pletzer.

R.C.S. Luxembourg B 136.812.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014133190/9.
(140151153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2014.

Keasy, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8080 Bertrange, 2, rue Pletzer.

R.C.S. Luxembourg B 136.812.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014133191/9.
(140151154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2014.

Knauf Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R.C.S. Luxembourg B 96.123.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014133198/9.
(140151321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2014.

Koromandel Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 57, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 167.515.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014133199/9.
(140151219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2014.

Krabi International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 99.957.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014133200/9.
(140151133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2014.

141410

L

U X E M B O U R G

M.O.W. S.A., Mail Order World S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 143.043.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Référence de publication: 2014133242/10.
(140150883) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2014.

Maisons du Monde Luxembourg, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 144.360.

Le bilan au 31.12.2013 et les documents y relatifs ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Lu-

xembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014133243/10.
(140150798) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2014.

SG Audit S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 75.908.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 août 2014.

SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2014134525/11.
(140152676) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2014.

Silver Star S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 49, rue Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 71.740.

Les comptes annuels du 01/01/2013 au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 Août 2014.

Signature.

Référence de publication: 2014134529/11.
(140152366) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2014.

Sonnenhof S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1341 Luxembourg, 3, place Clairefontaine.

R.C.S. Luxembourg B 162.454.

Le bilan au 31.12.2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
<i>Pour SONNENHOF S.A. SPF
Signature

Référence de publication: 2014134511/12.
(140152631) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2014.

141411

L

U X E M B O U R G

Sephir Participation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 251.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 166.410.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 août 2014.

Référence de publication: 2014134524/10.
(140152769) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2014.

Simius Promotions S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4830 Rodange, 3, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 106.895.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 26 août 2014.

Signature.

Référence de publication: 2014134530/10.
(140152605) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2014.

Société Financière du Méditerranéen S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine

Familial.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 11.632.

Les Bilans au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014134535/11.
(140152712) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2014.

Société Financière du Méditerranéen S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine

Familial.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 11.632.

Les Bilans au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014134536/11.
(140152713) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2014.

Stonegate Pub Company Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 100.000,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 156.172.

Suite à des changements d'adresse de certains associés de la Société, il y a lieu de noter que:
- TDR Capital Nominees Limited réside désormais au 20 Bentinck street, London W1U 2EU, England.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 août 2014.

Référence de publication: 2014134514/12.
(140152830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2014.

141412

L

U X E M B O U R G

Toiture Moderne N.E. Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7737 Colmar-Berg, Zone Industrielle Jean Piret.

R.C.S. Luxembourg B 111.833.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014134568/9.
(140152478) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2014.

Midas Holdco IV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 170.891.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014133821/9.
(140152147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2014.

Satofi S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 100.471.

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire tenue extraordinairement à Bertrange le 14 août

<i>2014 à 15 heures

Il résulte dudit procès-verbal que Monsieur Gérard BENICHOU, domicilié sis 23 rue Hillel St. Jérusalem, 94581 ISRAEL

a démissionné de sa fonction d'administrateur de la société avec effet immédiat.

Bertrange, le 14 août 2014.

<i>Pour SATOFI S.A.

Référence de publication: 2014134522/13.
(140152875) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2014.

Swedbank Management Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 149.317.

<i>Extrait de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 13 août 2014.

L'assemblée prend à l'unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Première résolution

L'assemblée décide d'élire au conseil d'administration de la Société en tant qu'administrateur de

<i>Catégorie A:

- Monsieur Pär-Ola LAURIN, né le 10 juin 1971 à Landskrona en Suède, demeurant professionnellement à Swedbank

AB (publ.), Landsvägen 40, SE-172 63 Sundbyberg, Suède, en remplacement de Monsieur Lars FRIBERG, Monsieur Fredric
BLOMMÉ-SEKUND et Madame Maria JANSON.

Le mandat de nouvel administrateur prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle de l'année 2015.
Le conseil d'administration de la Société est désormais composé des personnes suivantes:
- Monsieur Magnus CARLEHED
- Monsieur Pär-Ola LAURIN
- Madame Tiina NORBERG
- Monsieur Benjamin SWEDBERG
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 août 2014.

Ellinor ÖRTEGREN JOHANSSON.

Référence de publication: 2014134519/23.
(140152932) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2014.

141413

L

U X E M B O U R G

Re Schools S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.165.400,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 162.022.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Value Partners S.A.

Référence de publication: 2014134466/10.
(140152651) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2014.

St Charles Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 113.593.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 25/08/2014

L'Assemblée Générale décide d'accepter:
- la démission de l'administrateur unique Monsieur Michel Ntambwe Wa Ntambwe, né à Kinshasa, le 24 juillet 1966,

demeurant à L-2728 Luxembourg, 13, rue Jules Wilhelm à partir du 01/06/2014.

- la nomination de l'administrateur unique Mr Jean Paul JOST né le 30/11/1950 à Schifflange, demeurant à L-3393

Roedgen, 3, rue des Jardins à partir du 01/06/2014.

POUR EXTRAIT CONFORME

Luxembourg, le 25 août 2014.

Référence de publication: 2014134513/15.
(140152368) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2014.

Pine River Fixed Income Lux Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 50.000,00.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 185.634.

Il résulte des résolutions des actionnaires de la société en date du 22 août 2014, les décisions suivantes:
1. Révocation du gérant B suivant en date du 22 août 2014:
Mr. Carl Anders Peter Lundin, employé privé, né le 10 septembre 1976 à Kalmar (Suède) et demeurant profession-

nellement au 6D, Route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg.

2. Mr. Bernard Bronckart, employé privé, né le 21 octobre 1966 à Ougrée (Belgique) et demeurant professionnellement

au 6D, Route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg.

3. Nomination du gérant B suivant à partir du 22 août 2014 pour une période indéterminée:
Mme. Anne-Sophie Davreux, employée privé, née le 13 novembre 1989 à Arlon (Belgique) et demeurant profession-

nellement au 6D, Route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg

4. Nomination du gérant B suivant à partir du 22 août 2014 pour une période indéterminée:
Mme. Michelle McAdams-Origer, employée privé, née le 21 avril 1975 à Berlin (Allemagne) et demeurant profession-

nellement au 6D, Route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg

Il résulte des résolutions ci-dessus que le Conseil de Gérance se compose désormais comme suit:
- Mr. Jeffrey Allan Stolt, gérant A;
- Mr. Ronan Carroll, gérant B;
- Mme. Anne-Sophie Davreux, gérant B; et
- Mme. Michelle McAdams-Origer, gérant B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 25 août 2014.

Référence de publication: 2014134443/27.
(140152543) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2014.

141414

L

U X E M B O U R G

Likipi Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2538 Luxembourg, 1, Nicolas Simmer.

R.C.S. Luxembourg B 72.806.

<i>Extrait de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 02 septembre 2014

Le Conseil d'administration a décidé à l'unanimité de transférer le siège social de la Société du 26, boulevard Royal

L-2449 Luxembourg au 1, rue Nicolas Simmer L-2538 Luxembourg avec effet au 1 

er

 septembre 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour LIKIPI HOLDING S.A.
Alain Tircher / Charles Emond / Jean-Michel Hamelle
<i>Administrateur / Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2014138388/14.
(140156799) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2014.

Malva S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 175.524.

<i>Extrait des résolutions prises en date du 6 août 2014

- La démission de Monsieur Renaud LEONARD de son mandat de Gérant catégorie B de la société, avec effet immédiat,

est acceptée.

- Madame Kalliopi FOURNARI, né le 14 février 1981 à Thessalonique (Grèce), employée privée, demeurant profes-

sionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, est nommée au poste de Gérant catégorie B en remplacement
de Monsieur Renaud LEONARD, démissionnaire, avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.

Malva S.à r.l.

Référence de publication: 2014138399/15.
(140157234) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2014.

LOGOS IT Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5887 Alzingen, 427, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 65.954.

- Constituée suivant acte reçu par Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à L-NIEDERANVEN, en date du 15

juillet 1998, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n° 797 du 30 octobre 1998.

- Modifiée suivant acte reçu par Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à L-LUXEMBOURG, en date du
6 novembre 2013, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n° 71 du 8 janvier 2014.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social de la société en

date du 14 juillet 2014 que les mandats des membres du Conseil d'Administration et du délégué à la gestion journalière
actuellement en fonction sont renouvelés jusqu'à la prochaine assemblée qui se tiendra en 2015, comme suit:

<i>Aux postes d'administrateurs:

- Monsieur François GOURDON, demeurant 4, rue Coislin, F-57000 Metz.
- Monsieur Lionel CAPIAUX, employé privé, demeurant professionnellement à 15, boulevard Roosevelt, L-2450 Lu-

xembourg.

- Mademoiselle Jeanne PIEK, employée privée, demeurant professionnellement à 15, boulevard Roosevelt, L-2450

Luxembourg.

<i>Au poste de délégué à la gestion journalière:

- Monsieur François GOURDON, demeurant 4, rue Coislin, F-57000 Metz.

Luxembourg, le 3 septembre 2014.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Référence de publication: 2014138393/25.
(140157201) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2014.

141415

L

U X E M B O U R G

Lodging Products &amp; Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2514 Luxembourg, 15, rue Jean-Pierre Sauvage.

R.C.S. Luxembourg B 101.880.

Le bilan au au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014138391/9.
(140156936) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2014.

Lapi Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 65.238.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014138377/9.
(140157059) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2014.

Mc. Innovation S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Roda S.à r.l.).

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1260 Luxembourg, 5, rue de Bonnevoie.

R.C.S. Luxembourg B 188.062.

<i>Extrait suite à un contrat de cession de parts sociales signé le 13 juin 2014:

Suite à un contrat de cession de parts sociales signé sous seing privé en date du 13 juin 2014, entre:
1. La société VICTORY BUSINESS CENTER S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au

60, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg enregistrée au Registre de Commerce de Luxembourg, section B, numéro
174.540;

Et
1. Monsieur Shahar Sasi CHAHAM, né à Israël (Israël), le 31 mars 1977, demeurant à Hayarkon 177, 6345329 Tel Aviv,

Israël.

Il en résulte ce qui suit:
La société VICTORY BUSINESS CENTER S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au

60, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg enregistrée au Registre de Commerce de Luxembourg, section B, numéro
174.540,

déclare céder à Monsieur Shahar Sasi CHAHAM, né à Israël (Israël), le 31 mars 1977, demeurant à Hayarkon 177,

6345329 Tel Aviv, Israël,

12.500 parts sociales d'une valeur nominale de EUR 1,00 chacune de la société à responsabilité limitée de droit lu-

xembourgeois MC. Innovation S.à r.l. (anciennement RODA S.à r.l.) établie et ayant son siège social au 5, rue de Bonnevoie,
L-1260 Luxembourg, et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 188.062.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>MC. Innovation S.à r.l. (anciennement RODA S.à r.l.)

Référence de publication: 2014138418/27.
(140156790) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2014.

MBNA R&amp;L S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 89.976.

Les comptes annuels au 28 février 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014138417/9.
(140157052) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2014.

141416

L

U X E M B O U R G

Madinina S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 107.457.

Les comptes annuels 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Value Partners S.A

Référence de publication: 2014138413/10.
(140156616) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2014.

LDV Management II Meigerhorn II S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 138.072.

Les comptes annuels consolidés au 31 Décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014138379/10.
(140156653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2014.

New Energy Above Training, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 11, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 170.989.

<i>Extrait de résolution du 03 septembre 2014

Il a été décidé de transférer le siège social au 11, rue Gabriel Lippmann à L-5365 Munsbach.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 03.09.2014.

New Energy Above Training
Philippe GREGOIRE
<i>Gérant unique

Référence de publication: 2014138431/14.
(140156736) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2014.

New Blitz, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-4081 Esch-sur-Alzette, 42, rue Dicks.

R.C.S. Luxembourg B 181.757.

En date du 1 

er

 août 2014, a eu lieu la cession de parts sociales suivante:

Madame Maria Alexandra AGUIAR DA FONSECA, retraitée, née à Gomdomar (P) le 28 janvier 1948, demeurant à

L-4081 ESCH/ALZETTE, 42, rue Dicks a cédé:

cinquante (50) parts sociales à Monsieur Paulo Alexandre MARQUES PAIS, coffreur, né à Coimbra (P) le 12 février

1975, demeurant à L-4279 ESCH/ALZETTE, 19B, rue Pasteur,

Par suite de la prédite cession, la répartition des parts sociales s'établit comme suit:

Madame Maria Alexandra AGUIAR DA FONSECA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 parts sociales
Monsieur Paulo Alexandre MARQUES PAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 parts sociales
TOTAL: CENT PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts sociales

Monsieur Paulo Alexandre MARQUES PAIS est nommé dans sa fonction de gérant technique.
Madame Maria Alexandra AGUIAR DA FONSECA est nommée dans sa fonction de gérante administrative.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014138440/20.
(140157044) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2014.

141417

L

U X E M B O U R G

Open V-IT Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 145.375.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait

Suite à la mise en liquidation de la société du 24 juillet 2014 auprès du Notaire Edouard DELOSCH de résidence à

Diekirch en instance de dépôt au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, le liquidateur décide de clôturer
la liquidation et précise qu'en application de la loi du 10 août 1915 relatif aux sociétés commerciales et notamment de
l'article 9 de ladite loi les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans auprès de la
Fiduciaire Luxembourgeoise, ayant son siège à L -1220 Luxembourg au 246 rue de Beggen.

Luxembourg, le 30 juillet 2014.

M. Thierry REDER
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2014138446/17.
(140156880) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2014.

Platinum UCITS Funds SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 158.545.

<i>Extrait des résolutions prises par voie de résolution circulaire en date du 10 avril 2014

En date du 10 avril 2014, le Conseil d'Administration a décidé:
- d'accepter la démission de Monsieur Holger Emmel en qualité d'Administrateur de catégorie S2, avec effet au 21 mai

2014,

- de coopter Monsieur Robert Friedman, 631-20 Long Ridge Road, Stamford, CT -06902 USA, en qualité d'Adminis-

trateur de catégorie S2 avec effet au 21 mai 2014, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en
2014, en remplacement de Monsieur Holger Emmel, démissionnaire.

Luxembourg, le 3 septembre 2014.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Platinum Ucits Funds SICAV
Caceis Bank Luxembourg

Référence de publication: 2014138460/18.
(140157198) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2014.

Muller &amp; Associés S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 127.167.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue en date du 15 mai 2014

que:

Le mandat de Monsieur Fernand Ernster est arrivé à échéance, l'Assemblée décide d'élire aux fonctions d'administra-

teur pour un mandat d'une durée de un an:

- M. Fernand ERNSTER, né le 07 mars 1960 à Luxembourg demeurant au 27, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg
Le  mandat  d'administrateur  de  M.  Fernand  ERNSTER  prendra  fin  à  l'issue  de  l'Assemblée  Générale  Annuelle  des

actionnaires qui se tiendra en 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 septembre 2014

<i>Pour la Société
Un mandataire

Référence de publication: 2014138428/19.
(140156965) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2014.

141418

L

U X E M B O U R G

Naturfleesch S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8077 Bertrange, 212, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 139.877.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 3 septembre 2014.

Signature.

Référence de publication: 2014138439/10.
(140157139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2014.

Mavilla Immobilière S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4761 Pétange, 97, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 25.001.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 3 septembre 2014.

Signature.

Référence de publication: 2014138416/10.
(140157140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2014.

Octopus Development S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

R.C.S. Luxembourg B 181.317.

Par la présente, la société Sador Luxembourg S.A., enregistrée au registre du Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg sous le numéro B 130.745 vous informe qu'elle démissionne du mandat de commissaire aux comptes dans votre
société à partir des comptes annuels de l'exercice s'étalant du 22/10/2013 au 31/12/2014.

Luxembourg, le 03 septembre 2014.

Nathalie Crahay
<i>Administrateur

Référence de publication: 2014138451/13.
(140157229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2014.

Praxair Holding Latinoamérica, Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 133.277.795,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 174.199.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 31 juillet 2014 que:
- La démission de Monsieur Benoît Bauduin en tant que gérant de catégorie B de la Société a été acceptée avec effet

au 31 juillet 2014; et

- Monsieur Livio Gambardella, né le 2 décembre 1975 à Terlizzi, Italie, demeurant professionnellement au 16 avenue

Pasteur, L-2310 Luxembourg, a été nommé, avec effet au 31 juillet 2014, gérant de catégorie B, et ce pour une durée
indéterminée.

Le Conseil de gérance se compose désormais comme suit:
Monsieur Pierre Donck, gérant de catégorie A;
Madame Ann Heidinger, gérant de catégorie A;
Madame Inna Hörner, gérant de catégorie B;
Monsieur Livio Gambardella, gérant de catégorie B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 septembre 2014.

Référence de publication: 2014138463/21.
(140157108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2014.

141419

L

U X E M B O U R G

TRALUX, Société Générale de Travaux - Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.750.000,00.

Siège social: L-3254 Bettembourg, 156, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 12.975.

EXTRAIT

L'Assemblée générale ordinaire du 16 juin 2014 a accepté la démission de ses fonctions de gérant présentée par

Monsieur Jean-François PIQUET.

L'Assemblée a nommé en qualité de gérant, pour une durée indéterminée, Monsieur Franck BECHEREL, avec adresse

professionnelle à L-3254 Bettembourg, 156, route de Luxembourg.

Pour extrait conforme
TRALUX
Société Générale de Travaux - Luxembourg
Société à responsabilité limitée

Référence de publication: 2014136402/17.
(140155130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2014.

GC Extreme S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 121.969.

EXTRAIT

Il résulte du contrat de transfert de parts signé en date du 01 juin 2013, que les parts de la société, d'une valeur

nominale de EUR 1,- seront désormais réparties comme suit:

Désignation de l'associé

Nombre

de parts

sociales

Golub Capital CP Funding LLC, au 615 South DuPont Highway, City of Dover, County of Kent,
DE 19901, United States of America. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Luxembourg, le 26 août 2014.

Référence de publication: 2014134857/18.
(140153220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2014.

Pegasus Holdings (Belgium) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 172.976.

EXTRAIT

Transfert de parts sociales:
Il résulte du contrat de transfert de parts sociales, signé en date du 2 juin 2014 sous seing privé, que la totalité des

parts sociales de la Société détenues par Ares European Real Estate Fund IV LP, ont été transférées à Pegasus Master
Holdings (Belgium) S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 43, avenue John F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Société sous le numéro B189837, laquelle
détient désormais 100 parts sociales de la Société représentant l'entièreté de son capital.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 septembre 2014.

Pour extrait sincère et conforme
Sanne Group (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2014138458/19.
(140156943) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2014.

141420

L

U X E M B O U R G

RSM Cosal, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 81.126.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014136335/9.
(140154998) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2014.

Timone GP, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 172.519.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2014136396/11.
(140154761) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2014.

TCW/MAC Capital Ltd. Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 157.072.

Le Bilan et l’affectation du résultat au 31 Décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 Août 2014.

TCW/MAC Cpital Ltd. Luxembourg S.à.r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
<i>Gérant B

Référence de publication: 2014136399/14.
(140154634) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2014.

VLW Lion S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1973 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 178.197.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'Actionnaire unique en date du 28 août 2014 que:
- les démissions de Benno VEGERS et Juan LOZANO de leurs fonctions d'Administrateur de la société ont été ac-

ceptées;

- le Conseil d'Administration, en vertu de la loi du 25 août 2006 concernant les sociétés anonymes unipersonnelles et

en accordance avec l'article 10 des statuts de la Société, sera dorénavant composé que d'un Administrateur unique en la
personne de M. Christian WEYLAND. Ce dernier pourra engager la société par sa signature individuelle.

L'Actionnaire unique fait savoir que M. Christian WEYLAND a changé d'adresse professionnelle et demeure doréna-

vant à 9, Z.I. Bombicht, L-6947 Niederanven (Luxembourg).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 août 2014.

<i>Pour la Société
Un mandataire

Référence de publication: 2014136419/20.
(140154566) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2014.

141421

L

U X E M B O U R G

UrbaniaBT1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 37C, avenue John F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 188.640.

<i>1. Transfert de parts

Il résulte d'un contrat de transfert de parts sociales, signé en date du 20 août 2014, que l'associé unique de la Société,

AIM Services S.à r.l., a transféré la totalité des 1.250.000 parts sociales qu'il détenait dans la Société à:

- Baupost Private Investments A-1, L.L.C., une limited liability company, constituée et régie selon les lois du Delaware,

ayant son siège social à l'adresse suivante: 2711 Centerville Road, Suite 400, 19808 Wilmington, Delaware, Etats-Unis
d'Amérique, immatriculée auprès du Secretary of State of the State of Delaware sous le numéro 3245490 (95.000 parts
sociales);

- Baupost Private Investments B-1, L.L.C., une limited liability company, constituée et régie selon les lois du Delaware,

ayant son siège social à l'adresse suivante: 2711 Centerville Road, Suite 400, 19808 Wilmington, Delaware, Etats-Unis
d'Amérique, immatriculée auprès du Secretary of State of the State of Delaware sous le numéro 3245479 (40.500 parts
sociales);

- Baupost Private Investments C-1, L.L.C., une limited liability company, constituée et régie selon les lois du Delaware,

ayant son siège social à l'adresse suivante: 2711 Centerville Road, Suite 400, 19808 Wilmington, Delaware, Etats-Unis
d'Amérique, immatriculée auprès du Secretary of State of the State of Delaware sous le numéro 3245480 (229.000 parts
sociales);

- Baupost Private Investments BVII-1, L.L.C., une limited liability company, constituée et régie selon les lois du Delaware,

ayant son siège social à l'adresse suivante: 2711 Centerville Road, Suite 400, 19808 Wilmington, Delaware, Etats-Unis
d'Amérique, immatriculée auprès du Secretary of State of the State of Delaware sous le numéro 3245487 (73.375 parts
sociales);

- HB Cayman Limited, une company limited by shares, constituée et régie selon les lois des Îles Caïmans, ayant son

siège social à l'adresse suivante: Ugland House, South Church Street, KY1-1104 Grand Cayman, Îles Caïmans, immatri-
culée auprès du Registrar of Companies of the Cayman Islands sous le numéro 105376 (56.250 parts sociales);

- PB Cayman Limited, une company limited by shares, constituée et régie selon les lois des îles Caïmans, ayant son

siège social à l'adresse suivante: Ugland House, South Church Street, KY1-1104 Grand Cayman, Îles Caïmans, immatri-
culée auprès du Registrar of Companies of the Cayman Islands sous le numéro 105372 (31.250 parts sociales);

- YB Cayman Limited, une company limited by shares, constituée et régie selon les lois des Îles Caïmans, ayant son

siège social à l'adresse suivante: Ugland House, South Church Street, KY1-1104 Grand Cayman, Îles Caïmans,, immatri-
culée auprès du Registrar of Companies of the Cayman Islands sous le numéro 105375 (20.375 parts sociales);

- BVP-I Cayman XI Limited, une company limited by shares, constituée et régie selon les lois des Îles Caïmans, ayant

son siège social à l'adresse suivante: Ugland House, South Church Street, KY1-1104 Grand Cayman, îles Caïmans, im-
matriculée auprès du Registrar of Companies of the Cayman Islands sous le numéro MC- 283769 (58.000 parts sociales);

- BVP-III Cayman XI Limited, une company limited by shares, constituée et régie selon les lois des Îles Caïmans, ayant

son siège social à l'adresse suivante: Ugland House, South Church Street, KY1-1104 Grand Cayman, Îles Caïmans, im-
matriculée auprès du Registrar of Companies of the Cayman Islands sous le numéro MC- 283770 (28.375 parts sociales);

- BVP-IV Cayman IX Limited, une company limited by shares, constituée et régie selon les lois des Îles Caïmans, ayant

son siège social à l'adresse suivante: Ugland House, South Church Street, KY1-1104 Grand Cayman, Îles Caïmans, im-
matriculée auprès du Registrar of Companies of the Cayman Islands sous le numéro MC-266748 (455.375 parts sociales);

- Urbanía International Investments S.L., une sociedad limitada, constituée et régie selon les lois d'Espagne, ayant son

siège social à l'adresse suivante: 10, Calle Velazquez, 2a Planta, 28001 Madrid, Espagne, immatriculée auprès du Registro
Mercantil Central sous le numéro B-85877975 (125.000 parts sociales);

- Taconic Spain Associates I, L.L.C., une limited liability company, constituée et régie selon les lois de Delaware, ayant

son siège social à l'adresse suivante: 1209, Orange Street, 19801 Wilmington, Delaware, Etats-Unis d'Amérique, imma-
triculée auprès du Secretary of State of the State of Delaware sous le numéro 5580720 (37.500 parts sociales).

Les parts sociales de la Société sont désormais réparties comme suit:

- Baupost Private Investments A-1, L.L.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95.000 parts sociales

- Baupost Private Investments B-1, L.L.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40.500 parts sociales

- Baupost Private Investments C-1, L.L.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229.000 parts sociales
- Baupost Private Investments BVII-1, L.L.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73.375 parts sociales

- HB Cayman Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56.250 parts sociales

- PB Cayman Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31.250 parts sociales

- YB Cayman Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.375 parts sociales

141422

L

U X E M B O U R G

- BVP-I Cayman XI Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58.000 parts sociales

- BVP-III Cayman XI Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28.375 parts sociales

- BVP-IV Cayman IX Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455.375 parts sociales
- Urbania International Investments S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125.000 parts sociales
- Taconic Spain Associates I, L.L.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37.500 parts sociales

<i>2. Extrait des résolutions prises par les associés de la Société en date du 22 août 2014

En date du 22 août 2014, les associés de la Société ont pris les résolutions suivantes:
- de nommer Madame Anne Catherine GRAVE, gérant unique de la Société, en tant que gérant de classe B de la Société

avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée;

- de nommer Monsieur Collin J. BEECROFT, né le 22 août 1961 à San Diego, Californie, Etats-Unis d'Amérique, résidant

professionnellement à l'adresse suivante: 10, Saint James Avenue, Suite 1700, 02116 Boston, Massachusetts, Etats-Unis
d'Amérique, en tant que nouveau gérant de classe A de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée;

- de nommer Monsieur Mark FARBER, né le 19 mars 1954 à Passaic, New Jersey, Etats-Unis d'Amérique, résidant

professionnellement à l'adresse suivante: 10, Calle Velâzquez, 2a Planta, 28001 Madrid, Espagne, en tant que nouveau
gérant de classe A de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée;

- de nommer Madame Catherine KOCH, née le 12 février 1965 à Sarreguemines, France, résidant professionnellement

à l'adresse suivante: 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, en tant que nouveau gérant de classe B de la Société avec
effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.

Le conseil de gérance de la Société est désormais composé comme suit:
- Monsieur Collin J. BEECROFT, gérant de classe A
- Monsieur Mark FARBER, gérant de classe A
- Madame Anne Catherine GRAVE, gérant de classe B
- Madame Catherine KOCH, gérant de classe B
3. Extrait des résolutions prises par le conseil de gérance de la Société en date du 25 août 2014
En date du 25 août 2014, le conseil de gérance de la Société a pris la résolution suivante:
- de transférer le siège social de la Société du 19 rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg au 37C, Avenue John F. Kennedy,

L-1855 Luxembourg avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 août 2014.

UrbaniaBT1 S.à.r.l.
Signature

Référence de publication: 2014135258/90.
(140153414) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2014.

FVD House S.A., Société Anonyme,

(anc. VH In Solutions S.A.).

Siège social: L-5884 Hesperange, 304, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 163.280.

Im Jahre zweitausendvierzehn, den sechsten August.
Vor dem unterzeichneten Notar Martine DECKER, mit dem Amtssitz in Hesperange, Großherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

- Herr Stephan Blohm, Geschäftsführer, berufsansässig in L-5884 Hesperange, 304, route de Thionville,
welcher Komparent den Notar ersuchte folgendes zu beurkunden:
I.- Dass er der Alleingesellschafter der Aktiengesellschaft "VH IN SOLUTIONS S.A." (die „Gesellschaft“), mit Sitz in

L-6991 Moersdorf, 19, rue Jean Brachmond, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter Sektion
B Nummer 163280, ist,

gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Paul Bettingen, mit Amtssitz in Niederanven, am 29. August

2011, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 2630 vom 28. Oktober 2011,

abgeändert gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Jean Seckler, mit Amtssitz in Junglinster, am 15. März 2012,

veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1371 vom 2. Juni 2012.

II.- Dass das Gesellschaftskapital einunddreißigtausend Euro (31.000,-EUR) beträgt, eingeteilt in dreihundertzehn (310)

Aktien von jeweils einhundert Euro (100,- EUR), vollständig eingezahlt.

III.- Dass er als Alleingesellschafter, das gesamte Gesellschaftskapital vertretend, an Stelle der außerordentlichen Ge-

neralversammlung folgende Beschlüsse gefasst hat:

141423

L

U X E M B O U R G

<i>Erster Beschluss

Der Alleingesellschafter beschließt die Umbenennung der Gesellschaft in „FVD HOUSE SA“.

<i>Zweiter Beschluss

Der Alleingesellschafter beschließt den Gesellschaftssitz von L-6991 Moersdorf, 19, rue Jean Brachmond nach L-5884

Hesperange, 304, route de Thionville, zu verlegen.

<i>Dritter Beschluss

Der Alleingesellschafter beschließt die vollständige Neufassung der Satzung der Gesellschaft, wie folgt, in deutscher

Sprache:

Titel I. - Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Unter der Bezeichnung FVD HOUSE SA (hiernach die "Gesellschaft") besteht eine Aktiengesellschaft, welche

der gegenwärtigen Satzung (hiernach die „Statuten"), sowie den jeweiligen Gesetzesbestimmungen unterliegt.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Hesperange, (Großherzogtum Luxemburg).
Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss der Generalversammlung oder gegebenfalls des Alleingesellschafters an

jeden beliebigen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Filialen und Tochtergesellschaften, Agen-

turen und Büros sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften und

die Verwirklichung sonstiger Investitionen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung
oder auf andere Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die
Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann als Komplementär und Geschäftsführer von Gesellschaften oder ähnlichen gesellschaftsrechtli-

chen Strukturen mit unbeschränkter Haftung für alle Verbindlichkeiten und Schulden solcher Strukturen handeln.

Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit oder

ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüglichen
gesetzlichen Bestimmungen.

Zweck der Gesellschaft ist darüber hinaus, für eigene Rechnung oder Eigenbedarf, der Erwerb von Immobilien zu

Anlagezwecken, die Verwaltung und Verpachtung, sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland gelegener
Immobilien, soweit dies angezeigt ist, auch die Realisierung einer solchen Investition durch Verkauf oder auf andere Weise.

Die Gesellschaft kann außerdem alle anderen Operationen kommerzieller, industrieller, finanzieller, mobiliarer und

immobiliarer Art, welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern, ausfüh-
ren.

Titel II. - Kapital, Aktien

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreißigtausend Euro (31.000,- EUR), eingeteilt in dreihundertzehn (310)

Aktien von jeweils einhundert Euro (100,- EUR), voll eingezahlt.

Die Aktien der Gesellschaft sind Namensaktien (actions nominatives) oder Inhaberaktien (actions au porteur), nach

Wahl der Aktionäre.

An  Stelle  von  Einzelaktien  können  Zertifikate  über  eine  Mehrzahl  von  Aktien  ausgestellt  werden,  nach  Wahl  der

Aktionäre.

Die Gesellschaft darf im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ihre eigenen Aktien erwerben.
Das Gesellschaftskapital darf den gesetzlichen Bedingungen entsprechend erhöht oder reduziert werden.
Zählt die Gesellschaft nur eine Person, so wird diese als „Alleingesellschafter“ bezeichnet. Die Gesellschaft kann einen

Alleingesellschafter bei ihrer Gründung oder als Folge der Vereinigung sämtlicher Aktien in einer Hand haben. Das Ableben
oder die Auflösung des Alleingesellschafters bewirkt nicht die Auflösung der Gesellschaft.

Titel III. - Verwaltung

Art. 6. Die Gesellschaft wird verwaltet von einem Verwaltungsrat bestehend aus mindestens drei Mitgliedern, Gesell-

schafter oder nicht, welche für eine Höchstdauer von sechs Jahren von der Generalversammlung der Aktionäre ernannt
werden und von ihr jederzeit „ad nutum“ abberufen werden können. Die Verwaltungsratsmitglieder sind wiederwählbar.

Besteht die Gesellschaft jedoch nur aus einem Alleingesellschafter oder wird anlässlich einer Hauptversammlung der

Aktionäre festgestellt, dass sie nur noch einen Alleingesellschafter zählt, kann die Zusammensetzung des Verwaltungsrats
auf ein Mitglied beschränkt werden, welches als Alleinverwalter („administrateur unique“) bezeichnet wird, dies bis zur
nächsten auf die Feststellung der Existenz von mehr als einem Gesellschafter folgenden ordentlichen Hauptversammlung.

Sie bestimmt die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder, ihre Amtszeit und ihre Vergütung.

141424

L

U X E M B O U R G

Art. 7. Der Verwaltungsrat wird unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden ernennen.
Auf Antrag des Vorsitzenden kommt der Verwaltungsrat so oft zusammen, wie es das Interesse der Gesellschaft

erfordert. Er muss zusammenkommen, wenn zwei Verwaltungsratsmitglieder dies verlangen.

Falls sich der Verwaltungsrat auf einen Alleinverwalter beschränkt, ist dieser Artikel nicht anwendbar.

Art. 8. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Verwaltungs- und Veräußerungshandlungen im

Rahmen des Gesellschaftszweckes vorzunehmen. Alles was nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder die Statuten der
Generalversammlung der Aktionäre vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, unter den gesetzlichen Bedingungen Vorschüsse auf Dividenden auszuzahlen.

Art. 9. Die Gesellschaft wird in allen Umständen durch die Kollektivunterschrift von zwei (2) Verwaltungsratsmitglie-

dern rechtmäßig verpflichtet.

Falls die Gesellschaft einen (1) Alleinverwalter hat, wird sie durch dessen Einzelunterschrift verpflichtet.

Art. 10. Der Verwaltungsrat darf seine Befugnisse zur Führung der täglichen Geschäftsführung einem oder mehreren

Verwaltungsratsmitgliedern, welche delegierte Verwaltungsratsmitglieder genannt werden, übertragen.

Er darf ebenfalls die Führung der Gesellschaft oder einer Einzelabteilung einem oder mehreren Direktoren übertragen

und Spezialvollmachten für bestimmte Angelegenheiten einem oder mehreren Bevollmächtigen erteilen; dieselben brau-
chen nicht Aktionäre oder Verwaltungsräte zu sein.

Titel IV. - Aufsicht

Art. 11. Die Tätigkeiten der Gesellschaft und ihre Rechnungslegung werden von einem oder mehreren, von der Ge-

neralversammlung der Aktionäre oder gegebenenfalls von dem Alleingesellschafter, zu ernennende(n) unabhängige(n)
Wirtschaftsprüfer überwacht. Die Dauer ihres Mandates kann nicht sechs Jahre überschreiten. Der/Die Wirtschaftsprüfer
ist/sind wiederwählbar.

Titel V. - Generalversammlung

Art. 12. Die jährliche Generalversammlung tritt spätestens am 2. Donnerstag des Monats Mai um 10.30 Uhr am Ge-

sellschaftssitz oder an jedem anderen im Einberufungsschreiben genannten Ort im Großherzogtum Luxemburg zusam-
men.

Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Generalversammlung am ersten darauf folgenden Werktag statt.
Sofern die Gesellschaft einen Alleingesellschafter zählt, übt dieser die der Hauptversammlung der Aktionäre zufallenden

Befugnisse aus.

Titel VI. - Geschäftsjahr, Gewinnverteilung

Art. 13. Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom 1. Januar bis zum 31 Dezember eines jeden Jahres.

Art. 14. Der positive Saldo der Gewinn- und Verlustrechnung nach Abzug der allgemeinen Kosten und der Abschrei-

bungen bildet den Reingewinn der Gesellschaft. Jedes Jahr werden fünf Prozent des Reingewinns vorweggenommen und
der gesetzlichen Rücklage zugeführt. Diese Vorwegnahmen und Zuführungen sind nicht mehr zwingend vorgeschrieben,
wenn die Rücklage zehn Prozent des Kapitals erreicht hat, müssen jedoch wieder einsetzen bis zu seiner vollständigen
Wiederherstellung, wenn der Rücklagefonds zu einem gegeben Zeitpunkt aus welchem Grund auch immer in Anspruch
genommen worden ist.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.

Titel VII. - Auflösung, Liquidation

Art. 15. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre oder gegebenenfalls des Al-

leingesellschafters vorzeitig aufgelöst werden, welche(r) einen oder mehrere Liquidator(en) (natürliche oder juristische
Personen), ernennt und deren Befugnisse und Vergütungen festlegt.

Titel VIII. - Allgemeine Bestimmungen

Art. 16. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, sowie abgeändert,

finden ihre Anwendung überall wo gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.

<i>Vierter Beschluss

Der Alleingesellschafter beschließt die Abberufung des Verwalters Herr Michael von HOYER, sowie der Verwalterin

Frau Katia von HOYER.

<i>Fünfter Beschluss

Der Alleingesellschafter ernennt zu zwei neuen Verwaltungsratsmitgliedern der Gesellschaft für eine Dauer endend

am Schluss der ordentlichen Hauptversammlung des Jahres 2017:

141425

L

U X E M B O U R G

- Herr Francisc Stefan Anton DOKONAL, Geschäftsführer, geboren am 3. Dezember 1957 in Otelu Rosu (Rumänien),

berufsansässig in L-5884 Hesperange, 304, route de Thionville,

- Herr Stephan Blohm, Geschäftsführer, geboren am 25. Januar 1970 in Bremerhaven (Deutschland), berufsansässig,

in L-5884 Hesperange, 304, route de Thionville.

<i>Sechster Beschluss

Der Alleingesellschafter beschließt das Mandat des Rechnungsprüfers EUROPEAN AUDIT, Société à Responsabilité

Limitée, abzuberufen.

<i>Siebenter Beschluss

Der Alleingesellschafter ernennt zum Wirtschaftsprüfer für eine Dauer endend am Schluss der ordentlichen Haupt-

versammlung des Jahres 2017:

- die Gesellschaft mit beschränkter Haftung KPMG Luxembourg, mit Sitz in L-2520 Luxembourg, 9, Allée Scheffer,

eingetragen im Handelsund Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 149133.

Da die Tagesordnung somit erschöpft ist wird die Versammlung geschlossen um 17.50 Uhr.

<i>Schätzung der Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche die

Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Urkunde enstehen, beläuft sich auf ungefähr 1.300,- EUR.

Worüber Urkunde, Aufgenommen in Hesperange, Am Datum, wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen,

sowie Stand und Wohnhort bekannt, hat er mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Blohm, M. Decker.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 7 août 2014. Relation: LAC/2014/37554. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur ff. (signé): Carole Frising.

FÜR  GLEICHLAUTENDE  AUSFERTIGUNG,  Der  Gesellschaft  zwecks  Hinterlegung  bei  dem  Handels-und  Gesell-

schaftsregister erteilt.

Hesperange, den 14. August 2014.

Référence de publication: 2014135271/153.
(140153002) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2014.

Soparfi Codes Holding S.A., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5884 Hesperange, 304, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 189.748.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendvierzehn, den vierzehnten August.
Vor dem unterzeichneten Notar Martine DECKER, im Amtssitz in Hesperange.

Ist erschienen:

1.- Die Gesellschaft MEDIAN SERVICES (LUX) SA, mit Sitz in L-5884 Hesperange, 304, route de Thionville, eingetragen

im Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg Sektion B unter der Nummer 175.231.

hier rechtmäßig vertreten durch Herrn Yves Stocklausen, Privatangestellter, berufsansässig in 304, route de Thionville,

5884 Hesperange, Großherzogtum Luxemburg, aufgrund einer ihm ausgestellten privatschriftlichen Vollmacht gegeben
zu Hesperange am 11. August 2014,

welche Vollmacht nach gehöriger «ne varietur»-Unterzeichnung durch den Vollmachtnehmer und den amtierenden

Notar, gegenwärtiger Urkunde beigeborgen verbleibt, um mit ihr einregistriert zu werden.

Die erschienene Partei, vertreten wie vor erwähnt, ersucht den amtierenden Notar die Satzung einer Aktiengesell-

schaft, welche sie hiemit gründet, zu beurkunden wie folgt:

Titel I. - Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Unter der Bezeichnung SOPARFI Codes Holding S.A. (hiernach die "Gesellschaft") besteht eine Aktiengesell-

schaft,  welche  der  gegenwärtigen  Satzung  (hiernach  die  „Statuten"),  sowie  den  jeweiligen  Gesetzesbestimmungen
unterliegt.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Hesperange, (Großherzogtum Luxemburg).
Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss der Generalversammlung oder gegebenenfalls des Alleingesellschafters an

jeden beliebigen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.

141426

L

U X E M B O U R G

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Filialen und Tochtergesellschaften, Agen-

turen und Büros sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften und

die Verwirklichung sonstiger Investitionen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung
oder auf andere Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die
Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen, sowie der Erwerb, die Verwaltung und die Lizenzierung von
Schutzrechten, Technologierechten und geistigem Eigentum.

Die Gesellschaft kann als Komplementär und Geschäftsführer von Gesellschaften oder ähnlichen gesellschaftsrechtli-

chen Strukturen mit unbeschränkter Haftung für alle Verbindlichkeiten und Schulden solcher Strukturen handeln.

Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit oder

ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüglichen
gesetzlichen Bestimmungen.

Zweck der Gesellschaft ist darüber hinaus, für eigene Rechnung oder Eigenbedarf, der Erwerb von Immobilien zu

Anlagezwecken, die Verwaltung und Verpachtung, sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland gelegener
Immobilien, soweit dies angezeigt ist, auch die Realisierung einer solchen Investition durch Verkauf oder auf andere Weise.

Die Gesellschaft kann außerdem alle anderen Operationen kommerzieller, industrieller, finanzieller, mobiliarer und

immobiliarer Art, welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern, ausfüh-
ren.

Titel II. - Kapital, Aktien

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreißigtausend Euro (31.000,- EUR), eingeteilt in eintausend (1.000)

Aktien von jeweils einunddreißig Euro (31,- EUR).

Die Aktien der Gesellschaft sind Namensaktien (actions nominatives) oder Inhaberaktien (actions au porteur), nach

Wahl der Aktionäre.

An  Stelle  von  Einzelaktien  können  Zertifikate  über  eine  Mehrzahl  von  Aktien  ausgestellt  werden,  nach  Wahl  der

Aktionäre.

Die Gesellschaft darf im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ihre eigenen Aktien erwerben.
Das Gesellschaftskapital darf den gesetzlichen Bedingungen entsprechend erhöht oder reduziert werden.
Zählt die Gesellschaft nur eine Person, so wird diese als „Alleingesellschafter“ bezeichnet. Die Gesellschaft kann einen

Alleingesellschafter bei ihrer Gründung oder als Folge der Vereinigung sämtlicher Aktien in einer Hand haben. Das Ableben
oder die Auflösung des Alleingesellschafters bewirkt nicht die Auflösung der Gesellschaft.

Titel III. - Verwaltung

Art. 6. Die Gesellschaft wird verwaltet von einem Verwaltungsrat bestehend aus mindestens drei Mitgliedern, Gesell-

schafter oder nicht, welche für eine Höchstdauer von sechs Jahren von der Generalversammlung Hauptversammlung der
Aktionäre ernannt werden und von ihr jederzeit „ad nutum“ wieder abberufen werden können. Die Verwaltungsrats-
mitglieder sind wiederwählbar.

Besteht die Gesellschaft jedoch nur aus einem Alleingesellschafter oder wird anlässlich einer Hauptversammlung der

Aktionäre festgestellt, dass sie nur noch einen Alleingesellschafter zählt, kann die Zusammensetzung des Verwaltungsrats
auf ein Mitglied beschränkt werden, welches als Alleinverwalter („administrateur unique“) bezeichnet wird, dies bis zur
nächsten auf die Feststellung der Existenz von mehr als einem Gesellschafter folgenden ordentlichen Hauptversammlung.

Sie bestimmt die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder, ihre Amtszeit und ihre Vergütung.

Art. 7. Der Verwaltungsrat wird unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden ernennen.
Auf Antrag des Vorsitzenden kommt der Verwaltungsrat so oft zusammen, wie es das Interesse der Gesellschaft

erfordert. Er muss zusammenkommen, wenn zwei Verwaltungsratsmitglieder dies verlangen. Falls sich der Verwaltungsrat
auf einen Alleinverwalter beschränkt, ist dieser Artikel nicht anwendbar.

Der Verwaltungsrat tritt am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen in der Einberufung bezeichneten Ort zu-

sammen und fasst seine Beschlüsse, soweit nach Maßgabe der Gesetze und der Satzung zulässig, mit der einfachen Mehrheit
der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit hat der Vorstandsvorsitzende die ausschlaggebende Stimme.

Ein Mitglied des Verwaltungsrats darf an einer Sitzung im Wege einer Telefonkonferenz oder ähnlichen Kommunika-

tionsmitteln teilnehmen, soweit die an der Sitzung teilnehmenden Personen sich legitimieren, akustisch wahrnehmen und
beraten können. Die Teilnahme an einer Sitzung mit solchen Mitteln ist als gleichwertig mit einer persönlichen Anwe-
senheit an einer solchen Sitzung zu betrachten.

Beschlüsse des Verwaltungsrats können auch in der Form von schriftlichen Zirkularbeschlüssen, in einer oder meh-

reren getrennten Ausfertigung(en), fernmündlich, per Telefax, per E-Mail, in einer Telefon- oder Videokonferenz oder
mittels sonstiger gebräuchlicher Telekommunikationsmittel oder in einer Kombination dieser Verfahren getroffen wer-
den, falls Einstimmigkeit aller Mitglieder des Verwaltungsrats besteht und eine solche Abstimmung schriftlich bestätigt

141427

L

U X E M B O U R G

wird. Im Falle von getrennten Ausfertigungen der schriftlichen Zirkularbeschlüsse, werden solche als ausreichende Ent-
scheidungsprotokolle einer Entscheidung des Verwaltungsrats betrachtet. Zirkularbeschlüsse entfalten dieselbe Wirkung,
wie in einer ordnungsgemäß geladenen und abgehaltenen Sitzung gefasste Beschlüsse. Solche schriftlichen Beschlüsse sind
gefasst, wenn sie durch alle Verwaltungsratsmitglieder auf einem einzigen Dokument oder auf verschiedenen Duplikaten
datiert und unterzeichnet worden sind, wobei eine Kopie der Unterschrift, die per Post, per Faxschreiben, per E-Mail
oder durch jedes andere Kommunikationsmittel gesendet wurde, hinreichender Beweis dafür ist. Das Dokument, das alle
Unterschriften enthält, oder die Gesamtheit aller Duplikate, je nach Lage des Falles, stellt das Schriftstück dar, welches
das Fassen der Beschlüsse beweist, und das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum solcher Beschlüsse

Art. 8. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehendsten Befugnisse, alle Verwaltungs- und Veräußerungshandlungen im

Rahmen des Gesellschaftszweckes vorzunehmen. Alles was nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder die Statuten der
Generalversammlung der Aktionäre vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, unter den gesetzlichen Bedingungen Vorschüsse auf Dividenden auszuzahlen.

Art. 9. Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber rechtsverbindlich verpflichtet wie folgt:
- durch die Kollektivunterschrift von zwei (2) Verwaltungsratsmitgliedern, oder
- durch die Einzelunterschrift des Delegierten des Verwaltungsrates im Rahmen der täglichen Geschäftsführung, oder
- durch ein Verwaltungsratsmitglied zusammen mit einem Bevollmächtigten, der ein Prokurist, Angestellter oder Drit-

ter sein kann.

Falls die Gesellschaft einen (1) Alleinverwalter hat, wird sie durch dessen Einzelunterschrift verpflichtet.

Art. 10. Der Verwaltungsrat darf seine Befugnisse zur Führung der täglichen Geschäftsführung einem oder mehreren

Verwaltungsratsmitgliedern,  welche  delegierte  Verwaltungsratsmitglieder  genannt  werden,  oder  einen  oder  mehrere
Prokuristen, andere Angestellten oder Dritte übertragen. Er kann eine derartige Bevollmächtigung jederzeit widerrufen.

Er darf ebenfalls die Führung der Gesellschaft oder einer Einzelabteilung einem oder mehreren Direktoren übertragen

und Spezialvollmachten für bestimmte Angelegenheiten einem oder mehreren Bevollmächtigen erteilen; dieselben brau-
chen nicht Aktionäre oder Verwaltungsräte zu sein.

Titel IV. - Aufsicht

Art. 11. Die Tätigkeiten der Gesellschaft und ihre Rechnungslegung werden von einem oder mehreren, von der Ge-

neralversammlung der Aktionäre oder gegebenenfalls von dem Alleingesellschafter, zu ernennende(n) unabhängige(n)
Wirtschaftsprüfer überwacht. Die Dauer ihres Mandates kann nicht sechs Jahre überschreiten. Der/Die Wirtschaftsprüfer
ist/sind wiederwählbar.

Titel V. - Generalversammlung

Art. 12. Die jährliche Generalversammlung tritt spätestens am 2. Donnerstag des Monats Mai um 10.30 Uhr am Ge-

sellschaftssitz oder an jedem anderen im Einberufungsschreiben genannten Ort im Großherzogtum Luxemburg zusam-
men.

Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Generalversammlung am ersten darauf folgenden Werktag statt.
Sofern die Gesellschaft einen Alleingesellschafter zählt, übt dieser die der Hauptversammlung der Aktionäre zufallenden

Befugnisse aus.

Titel VI. - Geschäftsjahr, Gewinnverteilung

Art. 13. Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom 1. Januar bis zum 31 Dezember eines jeden Jahres.

Art. 14. Der positive Saldo der Gewinn- und Verlustrechnung nach Abzug der allgemeinen Kosten und der Abschrei-

bungen bildet den Reingewinn der Gesellschaft. Jedes Jahr werden fünf Prozent des Reingewinns vorweggenommen und
der gesetzlichen Rücklage zugeführt. Diese Vorwegnahmen und Zuführungen sind nicht mehr zwingend vorgeschrieben,
wenn die Rücklage zehn Prozent des Kapitals erreicht hat, müssen jedoch wieder einsetzen bis zu seiner vollständigen
Wiederherstellung, wenn der Rücklagefonds zu einem gegeben Zeitpunkt aus welchem Grund auch immer in Anspruch
genommen worden ist.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.

Titel VII. - Auflösung, Liquidation

Art. 15. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre oder gegebenenfalls des Al-

leingesellschafters vorzeitig aufgelöst werden, welche(r) einen oder mehrere Liquidator(en) (natürliche oder juristische
Personen), ernennt und deren Befugnisse und Vergütungen festlegt.

Titel VIII. - Allgemeine Bestimmungen

Art. 16. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, sowie abgeändert,

finden ihre Anwendung überall wo gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.

141428

L

U X E M B O U R G

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2014.
Die erste jährliche Generalversammlung findet statt im Jahr 2015.

<i>Zeichnung und Einzahlung des Kapitals

Das Gesellschaftskapital mit eintausend (1.000) Aktien zu je einem Nennwert von einunddreißig Euro (31,- EUR) wurde

vollständig von der alleinigen Gesellschafterin MEDIAN SERVICES (LUX) SA, vorbenannt, gezeichnet:

Alle Aktien sind bis zur Höhe von einem Viertel in bar eingezahlt, so dass der Gesellschaft ab heute der Betrag von

siebentausend siebenhundertfünfzig Euro (7.750.-EUR) zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachge-
wiesen wurde, welcher dies ausdrücklich bestätigt.

Die Aktien bleiben Inhaberaktien bis zur vollständigen Auszahlung.

<i>Erklärung:

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen des Artikel 26 des Gesetzes über die Handelsgesell-

schaften erfüllt sind.

<i>Kosten:

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, in welcher Form auch immer, die der Gesell-

schaft aus Anlass der Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr EUR 1.200,-.

<i>Beschlüsse des Einzelnen Gesellschafters:

Alsdann hat die eingangs erwähnte Komparentin, welche das gesamte Aktienkapital vertritt, an Stelle der außeror-

dentlichen Generalversammlung folgende Beschlüsse gefasst:

1) Der Sitz der Gesellschaft ist festgesetzt in 304, route de Thionville, L-5884 Hesperange.
2) Die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei (3) und diejenige der Wirtschaftsprüfer auf einen (1) fest-

gelegt.

3) Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt. Wie laut den gesetzlichen Bestimmungen und der vorliegenden

Satzung erlaubt, werden

Herr Stephan Blohm, geboren am 25. Januar 1970 in Bremerhaven (Deutschland), geschäftsansässig 304, route de

Thionville, 5884 Hesperange, Großherzogtum Luxemburg.

Herr Yves Stocklausen, geboren am 24. Juni 1968 in Esch/Alzette, geschäftsansässig 304, route de Thionville, 5884

Hesperange, Großherzogtum Luxemburg.

Herr Prof. Dr. Arnold Vahrenwald, geboren 17. Juli 1950 in 30989 Gehrden/Hannover, Deutschland, geschäftsansässig

Maximilianstr. 54, 80538 München, Deutschland.

4) Ist zum Kommissar bzw. Wirtschaftsprüfer ernannt die société à responsabilité limitée KPMG LUXEMBOURG, mit

Sitz in 9, Allee Scheffer, L-2520 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg unter der Nummer B 149133.

5) Die Mandate der Verwalter und des Kommissars bzw. Wirtschaftsprüfers enden am Schluss der jährlichen Haupt-

versammlung des Jahres 2016.

Worüber Urkunde, Aufgenommen zu Hesperange, Datum wie Eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehendem an den Vollmachtnehmer der Komparentin, dem Notar nach Namen, ge-

bräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, hat der Vollmachtnehmer mit dem Notar gegenwärtige
Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Stocklausen, M. Decker.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 21 août 2014. Relation: LAC/2014/39209. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur (signé): Irène Thill.

FÜR  GLEICHLAUTENDE  AUSFERTIGUNG,  der  Gesellschaft  zwecks  Hinterlegung  bei  dem  Handels-und  Gesell-

schaftsregister erteilt.

Hesperange, den 26. August 2014.

Référence de publication: 2014135212/181.
(140152938) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2014.

141429

L

U X E M B O U R G

Timea Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 7, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 189.775.

STATUTES

In the year two thousand fourteen, on the thirteenth of August.
Before us Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Herald Properties S.à r.l. a company with its registered office and its principal place of business at 7 Avenue Gaston

Diderich, L-1420 Luxembourg,

here represented by Mrs. Rachel HAFEDH, employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a power of

attorney, given under private seal.

Said proxies, after having been signed “ne varietur” by the proxyholder of the appearing parties and by the undersigned

notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, represented as above stated, have requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited company, which is hereby incorporated.

Art. 1. There is formed by the present appearing parties mentioned above and all persons and entities who may become

shareholders in the future, a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed by
the laws pertaining to such an entity, and in particular the law dated 10 

th

 August, 1915 on commercial companies, as

well as by the present articles (hereafter the "Company").

Art. 2. The object of the Company is the acquisition, management, development and sale, for its own account, directly

or indirectly, of real estate of any nature or origin, whatsoever, located in Luxembourg or any other jurisdiction.

The object of the Company is further the acquisition of participations in any form whatsoever, by purchase, exchange

or in any other way undertakings and companies either Luxembourg or foreign entities as well as the management, control,
and development of these participations. The Company may also carry out the transfer of these participations by means
of sale, exchange or otherwise. The Company may further acquire by subscription, purchase, and exchange or in any
other manner any stock, shares and other securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments
and more generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever.

The Company may take any controlling or supervisory measures and carry out any operations which it may deem

useful in the accomplishment of its object; it may also accept any mandate as director in other companies in Luxembourg
or foreign, remunerated or not.

The Company may also acquire and develop all patents, trademarks and other intellectual and intangible rights as well

as any other rights connected to them or which may complete them.

The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement only,

notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including the
proceeds  of  any borrowings and/or issues  of  debt securities  to  its subsidiaries,  affiliated companies  or to any  other
company. It may also give guarantees and grant security interests in favour of third parties to secure its obligations or the
obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further mortgage, pledge,
transfer, encumber or otherwise hypothecate all or some of its assets.

The Company may generally employ any techniques and utilize any instruments relating to its investments for the

purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against
credit risk, currency fluctuations risk, interest rate fluctuations risk and others risks.

The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to

real estate or movable property, which directly or indirectly further or relate to its the above described objects."

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name “Timea Properties S.à r.l.”.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg-City.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders. The address of the registered office may be transferred within the town limits
by a simple resolution of the manager or, in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 6. The Company's subscribed share capital is fixed at TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED EUROS (EUR

12,500.-) represented by FIVE HUNDRED (500) shares having a nominal value of TWENTY FIVE EUROS (EUR 25.-) per
share each.

141430

L

U X E M B O U R G

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the shareholders

meeting, in accordance with article 14 of these articles of association.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the law of 10 

th

 August, 1915 on commercial companies.

Art. 11. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the

shareholders will not bring the Company to an end.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed, revoked
and replaced by the general shareholder meeting, by a decision adopted by shareholders owning more than half of the
share capital.

In case of plurality of managers, the board of managers chooses among its members a chairman. Only a Luxembourg

Resident shall be designated as the Chairman. The first chairman may be appointed by the general meeting. In the case
the chairman is unable to carry out his duties, he is replaced by the manager designated to this effect by the board of
managers.

In dealing with third parties, the sole manager will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances

and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of
this article 12 shall have been complied with. In case of plurality of managers, such powers may only be exercised jointly
by any two managers of the Company unless delegated to a single manager further to a resolution of the board. All powers
not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders fall within the
competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers (acting as aforesaid).

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

signature of two members of the board of managers.

The general shareholders meeting, or the sole manager, or in case of plurality of managers, the board of managers

may delegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

The general shareholders meeting, or the sole manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will

determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any
other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

The meetings of the board of managers are convened by the chairman or by any two managers.
In case of plurality of managers, written notices of any meeting of the board of managers will be given to all managers,

in writing or by cable, telegram, telefax or telex, at least 24 hours in advance of the hour set for such meeting, except in
circumstances of emergency. This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they state
that they have been informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual meetings
held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers. Any
manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telefax or telex
another manager as his proxy. Managers may also cast their vote by telephone confirmed in writing. The board of managers
can deliberate or act validly only if at least the majority of its members are present or represented at a meeting of the
board of managers. Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing
in which case it shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager.
The date of such a resolution shall be the date of the last signature.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability

in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company in accordance with these articles
of association (including, for the avoidance of any doubt, article 12).

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number

of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions
are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority of the

shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital, subject to the provisions of the law of 10

th

 August, 1915, as amended.

141431

L

U X E M B O U R G

An annual general meeting of the shareholder(s) shall be held at the registered office of the Company, or at such other

place in the municipality of its registered office as may be specified in the notice of meeting. Other general meetings of
the shareholder(s) may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.

Art. 15. The Company's year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December.

Art. 16. Each year, with reference to 31 

st

 December, the Company's accounts are established and the manager, or

in case of plurality of managers, the board of managers prepares an inventory including an indication of the value of the
company's assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amor-

tisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share
capital. The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding
in the Company. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay interim
dividends.

Art. 18. At the time of winding up the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the law of 10 

th

 August, 1915, as amended, for all matters for which

no specific provision is made in these articles of association.

<i>Subscription and payment

All the five hundred (500) shares have been subscribed by Herald Properties S.à r.l., prenamed, and have been fully

paid up, so that the sum of twelve thousand and five hundred euros (EUR 12,500.-) corresponding to a share capital of
twelve thousand and five hundred euros (EUR 12,500.-) is forthwith at the free disposal of the Company, as has been
proved to the notary.

<i>Transitory provision

The first financial year shall begin today and it shall end on 31 

st

 December, 2014.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be born by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately one thousand one hundred fifty euros (EUR 1,150.-).

<i>Extraordinary general meeting

Immediately after the incorporation, the shareholder representing the entire subscribed capital of the Company has

herewith adopted the following resolutions:

1) The number of managers is set at two. The meeting appoints as managers of the Company for an unlimited period

of time:

a. Mrs. Rachel HAFEDH, manager, born on 22 March 1976 in Hayange (France), professionally residing in L-1420

Luxembourg, 7, Avenue Gaston Diderich;

c. Property and Finance Corporation S.à r.l., a company with its registered office and its principal place of business at

7 Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg,

2) The address of the registered office is established in L-1420 Luxembourg, 7, Avenue Gaston Diderich.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, Luxembourg, on the years and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder signed together with us,

the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le treize août.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

Herald Properties S.à r.l, une société constituée selon le droit du Grand Duché du Luxembourg, ayant son siège social

à L-1420 Luxembourg, 7, Avenue Gaston Diderich,,

141432

L

U X E M B O U R G

ici représentée par Madame Rachel HAFEDH, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu

d'une procuration donnée sous seing privé.

Lesdites procurations, après signature ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumen-

tant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquelles comparantes, agissant en-dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser l'acte constitutif

d'une société à responsabilité limitée et dont les statuts ont été arrêtés comme suit:

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes par les comparants et toutes les personnes qui pourraient devenir associés

par la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, et notamment celle du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (ci-après la «Société»).

Art. 2. La Société a pour objet l'acquisition, la gestion, le développement et la vente pour son propre compte, direc-

tement ou indirectement, de biens immobiliers de quelque nature ou origine que ce soit, situés au Luxembourg ou dans
tout autre pays.

L'objet social de la Société est également l'acquisition de participations sous quelque forme que ce soit, par achat,

échange ou de toute autre manière, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères ainsi que la gestion, le con-
trôle, la mise en valeur de ces participations. La Société pourra également acquérir par souscription, achat, et échange
ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt
et autres instruments de dette et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou
privée.

La Société pourra prendre toutes les mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toutes opérations qui peuvent

lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet; elle pourra également détenir des mandats d'administration d'au-
tres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, rémunérées ou non.

La Société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets, marques de fabrique et autres droits intellectuels

et incorporels ainsi que tous autres droits s'y rattachant ou pouvant les compléter.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder par

voie de placement privé, à l'émission de parts sociales et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de
créances. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des emprunts et/ou des
émissions d'obligations ou de valeurs, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toute autre société. La Société pourra consentir
des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou celles de ses filiales, sociétés
affiliées ou de toute autre société. La Société pourra aussi gager, nantir, grever, transférer, grever tout ou partie de ses
avoirs.

La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue

d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre le risque de crédit, les
fluctuations monétaires, fluctuations de taux d'intérêt et tout autre risque.

La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles, ainsi que toutes transactions

se rapportant à la propriété immobilière ou mobilière, qui directement ou indirectement favorisent ou se rapportent à
la réalisation de son objet tel que décrit ci-dessus.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de «Timea Properties S.à r.l.»

Art. 5. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés. L'adresse

du siège social peut être transférée endéans les limites de la commune de Luxembourg par simple décision du gérant ou,
en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut ouvrir des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu'à l'étranger.

Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500,-)

représenté par CINQ CENTS (500) parts sociales d'une valeur nominale de VINGT CINQ EUROS (EUR 25,-) chacune.

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l'associé unique sinon de l'assemblée

des associés, conformément à l'article 14 des présents statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l'actif social

ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune

d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule
et même personne.

Art. 10. Toutes cessions de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres.
En cas de pluralité d'associés, les parts sociales peuvent être cédées, à condition d'observer les exigences de l'article

189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

141433

L

U X E M B O U R G

Art. 11. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique, sinon d'un des associés, ne mettent pas

fin à la Société.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un conseil

de gérance. Le ou les gérant(s) n'ont pas besoin d'être associés. Le ou les gérants sont désignés, révoqués et remplacés
par l'assemblée des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance élit parmi ses membres un président. Seul un résidant du Luxem-

bourg  peut  être  élu  comme  président.  Le  premier  président  pourra  être  désigné  par  1'assemblée  générale.  En  cas
d'empêchement du président, le gérant désigné à cet effet par le conseil de gérance le remplace.

Vis-à-vis des tiers, le gérant unique a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances

et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l'objet social et sous réserve du respect des
dispositions du présent article 12. En cas de pluralité de gérants, ces pouvoirs sont conjointement exercés par deux
gérants de la Société, sauf s'ils ont été délégués à un gérant unique par une résolution du conseil de gérance.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale des associés

sont de la compétence du gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, de la compétence du conseil de gérance
(agissant conformément aux dispositions susmentionnées).

En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et en cas de pluralité de

gérants, par la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance.

L'assemblée des associés, ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer

ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

L'assemblée des associés, ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera la

responsabilité du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n'importe
quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

En cas de pluralité de gérants, les décisions du conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants

présents ou représentés.

Le conseil de gérance se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux gérants.
En cas de pluralité de gérants, avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants par écrit

ou par câble, télégramme, télex ou télécopie, au moins 24 heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence.
On pourra passer outre cette convocation si les gérants sont présents ou représentés au conseil de gérance et s'ils
déclarent avoir été informés de l'ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil
de gérance se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil
de gérance. Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie
un autre gérant comme son mandataire. Les gérants peuvent également voter par appel téléphonique, à confirmer par
écrit. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente
ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil
de gérance peut également être prise par voie circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les
résolutions et signés par tous les membres du conseil de gérance sans exception. La date d'une telle décision sera la date
de la dernière signature.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société conformément aux présents statuts (y compris, afin de
dissiper toute ambiguïté, l'article 12).

Art. 14. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés.
En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de

parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.
En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées
par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que par l'accord de la majorité

des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la loi du 10 août
1915, telle que modifiée.

Une assemblée générale annuelle de l'associé unique ou des associés se tiendra au siège social de la Société ou à tout

autre endroit de la commune de son siège social défini dans la convocation à l'assemblée.

D'autres assemblées générales de l'associé unique ou des associés peuvent être tenues aux lieux et places indiqués

dans la convocation.

Art. 15. L'année sociale de la Société commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre.

Art. 16. Chaque année, au trente-et-un décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le conseil

de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire et du bilan.

141434

L

U X E M B O U R G

Art. 17. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amor-

tissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde du bénéfice net est à la libre
disposition de l'assemblée générale. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra
décider de verser un dividende intérimaire.

Art. 18. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 19. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales de

la loi du 10 août 1915.

<i>Souscription et libération

Les cinq cents (500) parts sociales ont été souscrites par Herald Properties S.à r.l., précitée, et ont été entièrement

payées, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500.-) correspondant à un capital social de douze
mille cinq cents euros (EUR 12.500.-) soit à la disposition de la Société, comme il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2014.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à approximativement à mille cent cinquante euros (EUR
1.150,-).

<i>Assemblée générale constitutive

Immédiatement après la constitution de la Société, les associés préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit

ont pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre de gérant est fixé à deux. Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
a. Madame Rachel HAFEDH, gérante née le 22 mars 1976 à Hayange (France), demeurant professionnellement à L-1420

Luxembourg, 7, Avenue Gaston Diderich;

c. Property and Finance Corporation S.à r.l.,., une société constituée selon le droit du Grand Duché du Luxembourg,

ayant son siège social à L-1420 Luxembourg, 7, Avenue Gaston Diderich,

2. L'adresse du siège social de la société est établi à L-1420 Luxembourg, 7, Avenue Gaston Diderich.
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l'anglais, déclare que les comparantes l'ont requis de documenter le

présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et, en cas de divergence entre le texte anglais et le texte
français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: Rachel HAFEDH, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 18 août 2014. Relation GRE/2014/3342. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2014135222/311.
(140153476) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2014.

Karel S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 133.219.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Document faisant l’objet de la rectification:
Référence: L140136785
Date: 31/07/2014
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUO

Référence de publication: 2014134947/13.
(140153404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2014.

141435

L

U X E M B O U R G

20140726 Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 189.768.

STATUTES

In the year two thousand and fourteen, on the fourteenth of August,
Before us Maître Henri HELLINCKX, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

THERE APPEARED:

Emerging Markets Online Food Delivery Holding S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing

under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register
under number B 175738, having its registered address at 7, avenue J.P. Pescatore, L - 2324 Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg,

here represented by Ms Antje Reibold, Rechtsanwalt, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given

in Berlin, Germany on 7 August 2014 and in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 7 August 2014.

Said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to

this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such  appearing  party  has  requested  the  officiating  notary  to  enact  the  deed  of  incorporation  of  a  private  limited

company (société à responsabilité limitée) which it wishes to incorporate with the following articles of association:

A. Name - Purpose - Duration - Registered office

Art. 1. Name - Legal Form. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name

20140726 Holding S.à r.l. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning
commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.

Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign

companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio in view of its realisation by sale, exchange or otherwise.

2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it

holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the
Company.

2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by

issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.

2.4 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities

which it considers useful for the accomplishment of these purposes.

Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of

managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution
of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution

of the board of managers.

4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances

or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
traordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwiths-
tanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

B. Share capital - Shares

Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), represented by:

141436

L

U X E M B O U R G

5.1.1 one thousand two hundred fifty (1,250) common shares, with a nominal value of one euro (EUR 1) each (the

“Common Shares”); and

5.1.2 eleven thousand two hundred fifty (11,250) series A shares, with a nominal value of one euro (EUR 1) each (the

“Series A Shares”).

5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.3 The Company may redeem its own shares.

Art. 6. Shares.
6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of

the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.

Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection

by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.

7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall

appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.

7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given

by the shareholders at a majority of three quarters of the share capital.

7.5 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of

the transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

7.6 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject

to the approval of such transfer given by the surviving shareholders at a majority of three quarters of the share capital.
Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving
spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.

Art. 8. Liquidation and sale preferences.
8.1 In case (i) of any sale of at least 50% of all shares in the Company, or a swap or a take-over of the Company in an

economically comparable way in a single or more related transactions or in close time proximity to one another, or (ii)
of the liquidation of the Company or (iii) of any sale or transfer of shares in the Company either to third parties or other
shareholders that would result in either more than 50% of the share capital or more than 50 % of the voting rights being
owned by the acquiring party/parties (change of control) as a result of one or more related acquisitions (each of the
events described in (i), (ii) and (iii) is hereinafter referred to as a “Liquidity Event”), the proceeds (“Exit Proceeds”) -
subject to Article 8.2 below - will be distributed in accordance with Article 8.3 to the shareholders pro rata to their
participation in the Liquidity Event.

8.2 On a first level (“First Level”) the respective shareholder shall receive an amount equal to its total investment

made in the Company in order to acquire the respective Series A Shares held by it, consisting of the nominal amount of
the Series A Shares acquired and any share premium and/or other capital contribution (account 115) paid by it to the
Company.

8.3 After the payments on the First Level have been made, the remaining Exit Proceeds shall be allocated on a second

level (“Second Level”) to all selling Shareholders pro rata to their participation in the Liquidity Event. Any amounts received
by any shareholder on the First Level shall reduce the amount to be allocated to such shareholder on this Second Level
provided that no shareholder shall be obliged to repay any amount received on the First Level. Irrespective of whether
or not the sale of shares is made in one Liquidity Event or after the Liquidity Event in one transaction or more transactions,
no shareholder shall receive for the sale of all of its shares (and shall repay any exceeding amount to the other share-
holders) an amount exceeding the higher of (i) its share in the total Exit Proceeds or proceeds pro rata to the shares
sold on a common equivalent basis or (ii) the amount allocated to such shareholder on the First Level and/or Second
Level from a subsequent sale. All rights related to the liquidity preference stipulated herein can only be exercised once.

8.4 The preferred allocation of Exit Proceeds on the First Level applies for the benefit of the respective shareholder

so long as the respective shareholder has not yet received the full amount that is to be allocated to such shareholder
according to the First Level.

141437

L

U X E M B O U R G

C. Decisions of the shareholders

Art. 9. Collective decisions of the shareholders.
9.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles

of association.

9.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
9.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise

conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case,
each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his
vote in writing.

9.4 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of

shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by
the sole shareholder.

Art. 10. General meetings of shareholders. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, at least

one general meeting of shareholders shall be held within six (6) months of the end of each financial year in Luxembourg
at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the convening notice of such meeting.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices
of meeting. If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived
any convening requirement, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 11. Quorum and vote.
11.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
11.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company's

shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share
capital. If this majority is not reached in a first meeting or proposed written resolution, the shareholders may be convened
a second time with the same agenda or receive such proposed written resolution a second time by registered letter,
decisions are validly adopted in so far as they are adopted by a majority of the votes validly cast whichever is the fraction
of the share capital represented.

Art. 12. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.

Art. 13. Amendments of the articles of association. Any amendment of the articles of association requires the approval

of (i) a majority of shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.

D. Management

Art. 14. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
14.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers

form a board of managers.

14.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not

expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of
association is to be construed as a reference to the “sole manager”.

14.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any

actions necessary or useful to fulfil the Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the
Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.

Art. 15. Appointment, removal and term of office of managers.
15.1 The manager(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remune-

ration and term of office.

15.2 The managers shall be appointed and may be removed from office at any time, with or without cause, by a decision

of the shareholders representing more than half of the Company's share capital.

15.3 The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two (2) different classes, being class A

managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant
shareholders resolutions and the managers be identified with respect to the class they belong.

Art. 16. Vacancy in the office of a manager.
16.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or

otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the replaced manager by the remaining  managers until  the next meeting of shareholders  which shall  resolve  on  the
permanent appointment, in compliance with the applicable legal provisions.

141438

L

U X E M B O U R G

16.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company's sole manager, such vacancy must be filled without undue

delay by the general meeting of shareholders.

Art. 17. Convening meetings of the board of managers.
17.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held

at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.

17.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four (24) hours at

least in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document
being sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location
determined in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.

17.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive

any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of
managers.

Art. 18. Conduct of meetings of the board of managers.
18.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not

need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

18.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may

appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any
such meeting.

18.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either

in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.

18.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other

means of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis
and allowing an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a
participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.

18.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or

represented at a meeting of the board of managers.

18.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,

if any, shall not have a casting vote. In the event where the general meeting of shareholders has appointed different classes
of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only be validly
taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which may be
represented).

18.7. The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in

writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be
the date of the last signature.

Art. 19. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
19.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by

the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. In the event the general meeting of
shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers), such minutes
shall be signed by one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation). Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman,
if any, or by any two (2) managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of
managers (namely class A managers and class B managers), such copies or excerpts shall be signed by one (1) class A
manager and one (1) class B manager (including by way of representation).

19.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or

excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.

Art. 20. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the

signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers;
in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers
and class B managers), the Company will only be validly bound by the joint signatures of at least one (1) class A manager
and one (1) class B manager (including by way of representation) or (ii) by the joint signatures or the sole signature of
any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such
delegation.

141439

L

U X E M B O U R G

E. Audit and supervision

Art. 21. Auditor(s).
21.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company

shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.

21.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting

of shareholders.

21.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
21.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d'entreprises agréé

(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies' register and the
accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.

21.5. An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its

approval.

F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends

Art. 22. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end

on the thirty-first of December of the same year.

Art. 23. Annual accounts and allocation of profits.
23.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of

the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.

23.2. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve.

This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten
per cent (10%) of the share capital of the Company.

23.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the

contributing shareholder agrees with such allocation.

23.4 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does

not exceed ten per cent (10%) of the share capital.

23.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the

remainder of the Company's profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.

23.6 Subject to Article 8, distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they

hold in the Company.

Art. 24. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
24.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared

by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may
not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable
reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles
of association do not allow to be distributed.

24.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the share-

holders subject to the provisions of the Law and these articles of association.

G. Liquidation

Art. 25. Liquidation.
25.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the

liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders
deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided,
the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the
Company.

25.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the shareholders in proportion to the number of shares of the Company held by them.

H. Final clause - Governing law

Art. 26. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance

with the Law.

<i>Transitional provisions

1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 31 December

2014.

2. Interim dividends may be distributed during the Company's first financial year.

141440

L

U X E M B O U R G

<i>Subscription and payment

The one thousand two hundred fifty (1,250) common shares and eleven thousand two hundred fifty (11,250) series A

shares, with a nominal value of one euro (EUR 1) each, issued have been subscribed by Emerging Markets Online Food
Delivery Holding S.à r.l., aforementioned, for the price of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.00).

The shares so subscribed are fully paid-up by a contribution in cash so that the amount of twelve thousand five hundred

euro (EUR 12,500) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

The total contribution in the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) is entirely allocated to the

share capital.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be

borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately EUR 1,500.-.

<i>Resolutions of the sole shareholder

The incorporating shareholder, representing the entire share capital of the Company and having waived any convening

requirements, has thereupon passed the following resolutions:

1. The address of the registered office of the Company is set at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of

Luxembourg.

2. The following persons are appointed as class A manager of the Company for an unlimited term:
- Mr Christian Senitz, born in Aschersleben, Germany, on 27 January 1978, professionally residing at Johannisstrasse

20, D-10117 Berlin;

- Mr Ralf Wenzel, born in Berlin, Germany, on 8 August 1979, professionally residing at Johannisstrasse 20, D-10117

Berlin, Germany.

The following person is appointed as class B manager of the Company for an unlimited term:
- Mr Ulrich Binninger, born in Trier, Germany, on 30 August 1966, professionally residing at 19, rue des Lilas, L-8035

Strassen, Luxembourg.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,

this deed is worded in English followed by a German translation; at the request of the same appearing party and in case
of divergence between the English and the German text, the English version shall prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name

and residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausendvierzehn, am vierzehnten August.
Vor uns, Henri HELLINCKX, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,

IST ERSCHIENEN:

Emerging Markets Online Food Delivery Holding S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach deutschem

Recht, eingetragen im Luxemburger Gesellschaft- und Handelsregister, unter der Nummer B 175738, mit Sitz in 7, avenue
J.P. Pescatore, L - 2324 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,

hier vertreten durch Frau Antje Reibold, Rechtsanwalt, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom

7. August 2014, ausgestellt in Berlin, Deutschland und einer Vollmacht 7. August 2014 ausgestellt in Luxemburg, Groß-
herzogtum Luxemburg.

Besagte  Vollmacht,  welche  von  der  erschienenen  Partei  und  dem  unterzeichnenden  Notar  ne  varietur  paraphiert

wurde, wird der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.

Die erschienene Partei hat den amtierenden Notar ersucht, die Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung

(société à responsabilité limitée) zu beurkunden, welche sie mit der folgenden Satzung gründen möchte:

A. Name - Zweck - Dauer - Sitz

Art. 1. Name - Rechtsform. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée)

mit dem Namen 20140726 Holding S.à r.l. (die “Gesellschaft”), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August
1915 über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Ge-

sellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder

141441

L

U X E M B O U R G

auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kontrolle
und Entwicklung ihrer Beteiligungen im Hinblick auf deren Verwertung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Art.

2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder

Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören Garantien geben,
Sicherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.

2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere

durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und
Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheine bzw. Wertpapieren.

2.4 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur vornehmen

sowie solche, welche das geistige Eigentum betreffen oder im Zusammenhang mit Grundeigentum stehen und die ihr zur
Erreichung dieser Zwecke förderlich erscheinen.

Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden,

welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird.

Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in der Stadt Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Rates der Geschäftsführer

verlegt werden. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderli-
chen Art und Weise gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer im

Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.

4.4 Sollte der Rat der Geschäftsführer entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale

Entwicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an
ihrem  Gesellschaftssitz  beeinträchtigen  könnten,  so  kann  der  Gesellschaftssitz  bis  zur  endgültigen  Beendigung  dieser
außergewöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben
keine Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes
eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) aufgeteilt in
5.1.1 ein tausendzweihundertfünfzig (1.250) Stammanteile mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Anteil

(die „Stammanteile“); und

5.1.2 elftausendzweihundertfünfzig (11.250) Anteile der Serie A mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro

Anteil (die „Serie A Anteile“).

5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-

zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.

5.3 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen.

Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit jeweils dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht über-

schreiten darf.

6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs, die Insolvenz

oder ein vergleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.

Art. 7. Anteilsregister - Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden

kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.

7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten

wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft
ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.

7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.

141442

L

U X E M B O U R G

7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern mit

einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden.

7.5 Jede Übertragung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten gemäß Artikel 1690 des Code Civil

wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung zugestimmt
hat.

7.6 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters an neue Gesellschafter nur mit Zustimmung von

Gesellschaftern mit einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden. Eine derartige Zu-
stimmung ist nicht erforderlich, wenn die Anteile an Eltern, Nachkommen oder den/die überlebende/n Ehepartner/in
übertragen werden oder jedem anderem gesetzlichen Erben des verstorbenen Gesellschafters.

Art. 8. Liquidations- und Verkaufspräferenzen.
8.1 Im Falle (i) eines Verkaufs von mindestens 50% aller Anteile an der Gesellschaft oder eines Tausches oder einer

Übernahme der Gesellschaft in wirtschaftlich vergleichbarer Weise in einer oder mehreren Transaktionen oder in zeit-
licher Nähe zueinander, oder (ii) der Liquidation der Gesellschaft oder (iii) des Verkaufs oder der Übertragung von
Anteilen an der Gesellschaft entweder an Dritte oder an andere Gesellschafter, was dazu führen würde, dass entweder
mehr als 50% des Gesellschaftskapitals oder mehr als 50% der Stimmrechte im Besitz der erwerbenden Partei bzw.
Parteien wären (change of control), als Ergebnis eines oder mehrerer verbundener Akquisitionen, (wobei jeder der unter
(i), (ii) und (iii) beschriebenen Fälle im Folgenden als „Liquiditätsereignis“ bezeichnet wird), werden die Erlöse („Exiter-
löse“) - vorbehaltlich des Artikels 8.2 - im Einklang mit Artikel 8.3 auf einer pro rata-Basis entsprechend ihrer Beteiligung
am Liquiditätsereignis an die Gesellschafter verteilt.

8.2 Auf einer ersten Ebene („Erste Ebene”) erhält der jeweilige Gesellschafter einen Betrag, welcher dem Betrag seiner

jeweiligen Gesamtinvestition in die Gesellschaft entspricht, welche er aufgebracht hat, um Anteile der Serie A zu erwerben,
bestehend aus dem Nominalwert der Anteile der Serie A und dem Agio und/oder anderen Kapitaleinlage (Konto 115 des
Standardisierten Luxemburgischen Kontenplans), die von diesem Gesellschafter an die Gesellschafter gezahlt wurden.

8.3 Nachdem die Zahlungen auf der Ersten Ebene geleistet wurden, werden die übrigen Exiterlöse auf einer zweiten

Ebene („Zweite Ebene“) an alle verkaufenden Gesellschafter auf einer pro rata-Basis entsprechend ihrer Beteiligung am
Liquiditätsereignis verteilt. Sämtliche von einem Gesellschafter auf der Ersten Ebene erhaltenen Beträge mindern den von
diesem Gesellschafter zu erhaltenden Betrag auf dieser Zweiten Ebene mit der Maßgabe, dass kein Gesellschafter zur
Rückzahlung eines auf der Ersten Ebene erhaltenen Betrags verpflichtet ist. Die Zuteilung auf der Gemeinsamen Ebene
erfolgt solange, bis alle Exiterlöse an die Gesellschafter verteilt wurden. Unabhängig davon, ob der Verkauf von Anteilen
während eines Liquiditätsereignisses oder danach in einer oder mehreren Transaktionen erfolgt oder nicht, hat kein
Gesellschafter für den Verkauf all seiner Anteile einen Betrag zu erhalten (und übersteigende Beträge an die anderen
Gesellschafter zurückzuzahlen), der höher ist, (i) als sein Anteil an der Gesamtheit der Exiterlöse oder Erlöse auf einer
pro rata-Basis zu den Anteilen, die auf einer gemeinsamen und gleichwertigen Basis verkauft wurden oder (ii) als der
Betrag, der diesem Gesellschafter auf der Ersten und/oder Zweiten Ebene aus einem späteren Verkauf zugeteilt wurde.
Sämtliche mit der hierin festgelegten Liquiditätspräferenz verbundenen Rechte können nur einmal ausgeübt werden.

8.4 Die bevorzugte Zuteilung von Exiterlösen auf der Ersten Ebene gilt zugunsten des jeweiligen Gesellschafters so

lange, wie der jeweilige Gesellschafter noch nicht den ihm auf der Ersten Ebene zustehenden Gesamtbetrag erhalten hat.

C. Entscheidungen der Gesellschafter

Art. 9. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
9.1 Die Gesellschafterversammlung ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch das Gesetz und diese Satzung

übertragen wurden.

9.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.
9.3 Falls und solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, dürfen gemeinsame Ent-

scheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung vorbehalten wären, schriftlich gefasst werden. In diesem
Fall  erhält  jeder  Gesellschafter  den  Text  der  Beschlüsse  oder  Entscheidungen  in  ausformulierter  Form  und  übt  sein
Stimmrecht schriftlich aus.

9.4 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschriften

des Abschnitts XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jeder Bezug auf die „Gesellschafter-
versammlung“ in der vorliegenden Satzung als Bezug auf den Alleingesellschafter, je nach Zusammenhang und soweit
anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingesellschafter ausgeübt.

Art. 10. Gesellschafterversammlung. Falls die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, muss jähr-

lich innerhalb von sechs (6) Monaten vor dem Ende des Geschäftsjahres mindestens eine Gesellschafterversammlung in
Luxemburg am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort abgehalten werden, wie in der Einberufungsbekanntma-
chung zu dieser Versammlung genauer bestimmt. Andere Gesellschafterversammlungen finden an dem Ort und zu der
Zeit  statt,  welcher  in  der  entsprechenden  Einberufungsbekanntmachung  genauer  bestimmt  werden.  Falls  alle  Gesell-
schafter in einer Versammlung anwesend oder vertreten sind und auf sämtliche Einberufungsformalitäten verzichtet haben,
kann die Gesellschafterversammlung auch ohne vorherige Ankündigung oder Veröffentlichung abgehalten werden.

141443

L

U X E M B O U R G

Art. 11. Quorum und Abstimmung.
11.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.
11.2 Vorbehaltlich anderer Regelungen dieser Satzung oder des Gesetzes, die ein höheres Mehrheitsverhältnis vor-

sehen, bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von Gesellschaftern, die mehr als die
Hälfte des Gesellschaftskapitals halten. Falls diese Mehrheit in einer ersten Gesellschafterversammlung oder einer ersten
schriftlichen Konsultation der Gesellschafter nicht erreicht wird, können die Anteilseigner ein weiteres Mal mit derselben
Tagesordnung einberufen werden oder per Einschreiben dieselben schriftlichen Beschlussvorschläge erhalten und Ent-
scheidungen werden wirksam mit der Mehrheit der wirksam abgegebenen Stimmen gefasst, unabhängig vom Anteil des
durch sie vertretenen Gesellschaftskapitals.

Art. 12. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.

Art. 13. Änderung der Satzung. Eine Änderung der Satzung erfordert die Zustimmung (i) einer Mehrheit der Gesell-

schafter, die mindestens (ii) eine Mehrheit von drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertritt.

D. Geschäftsführung

Art. 14. Befugnisse des alleinigen Geschäftsführers - Zusammensetzung und Befugnisse des Rates der Geschäftsführer.
14.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Ge-

schäftsführer hat, bilden diese einen Rat der Geschäftsführer.

14.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „alleiniger Ge-

schäftsführer“ nicht ausdrücklich verwendet wird, ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Rat der Geschäftsführer“
als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer“ auszulegen.

14.3 Der Rat der Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse im Namen der Gesellschaft zu handeln

und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.

Art. 15. Ernennung, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
15.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung ernannt, welche ihre Bezüge und

Amtszeit festlegt.

15.2 Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund durch einen Beschluss von Gesellschaftern, die mehr als die

Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, ernannt oder abberufen werden.

15.3 Die Gesellschafterversammlung kann die Ernennung von Geschäftsführern zwei (2) unterschiedlicher Kategorien

beschließen, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Eine solche Klassifizierung
der Geschäftsführer muss ordnungsgemäß im Protokoll der betreffenden Gesellschafterbeschlüsse festgehalten und die
Geschäftsführer der Kategorie, der sie angehören, zugeordnet werden.

Art. 16. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
16.1 Scheidet ein Geschäftsführer durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Insolvenz, Rücktritt oder aus einem anderen Grund

aus seinem Amt aus, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen die ur-
sprüngliche Amtszeit nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesellschafterversammlung ausgefüllt werden,
welche im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die endgültige Ernennung entscheidet.

16.2  Für  den  Fall, dass der alleinige  Geschäftsführer aus  seinem Amt ausscheidet,  muss  die frei gewordene Stelle

unverzüglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.

Art. 17. Einladung zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
17.1 Der Rat der Geschäftsführer versammelt sich auf Einberufung eines beliebigen Geschäftsführers. Die Sitzungen

des Rates der Geschäftsführer finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.

17.2  Die  Geschäftsführer  werden  mindestens  vierundzwanzig  (24)  Stunden  vor  dem  für  die  Sitzung  anberaumten

Zeitpunkt zu jeder Sitzung des Rates der Geschäftsführer schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe
der Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Geschäftsführer
schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abgege-
ben haben, wobei eine Kopie eines solchen unterzeichneten Dokuments ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung
zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss
des Rates der Geschäftsführer bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.

17.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle

Einladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Rates
der Geschäftsführer diesen zugestimmt und diese unterzeichnen.

Art. 18. Durchführung von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
18.1 Der Rat der Geschäftsführer kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Rat der Ge-

schäftsführer kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise selbst ein Geschäftsführer sein muss
und der für die Protokollführung der Sitzungen des Rates der Geschäftsführer verantwortlich ist.

141444

L

U X E M B O U R G

18.2 Sitzungen des Rates der Geschäftsführer werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Rates der Ge-

schäftsführer  geleitet.  In  dessen  Abwesenheit  kann  der  Rat  der  Geschäftsführer  ein  anderes  Mitglied  des  Rates  der
Geschäftsführer  durch  einen  Mehrheitsbeschluss  der  anwesenden  oder  vertretenen  Mitglieder  als  Vorsitzenden  pro
tempore ernennen.

18.3 Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer teilnehmen, indem er ein anderen

Geschäftsführer schriftlich, per Faxschreiben, EMail oder durch ein anderes vergleichbares Kommunikationsmittel be-
vollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Geschäftsführer kann einen
oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.

18.4 Eine Sitzung des Rates der Geschäftsführer kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein

anderes Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu
hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel
ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung gilt als am Sitz der Ge-
sellschaft abgehalten.

18.5 Der Rat der Geschäftsführer kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest die Mehrheit seiner

Mitglieder in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.

18.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Rates der Geschäftsführer

teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden,
hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme. Sofern die Gesellschafterversammlung jedoch unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden Beschlüsse des Rates der Geschäftsführer nur dann wirksam gefasst, wenn sie von der Mehrheit
der Geschäftsführer einschließlich mindestens eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsführers der
Kategorie B (oder deren Vertreter) gefasst werden.

18.7 Der Rat der Geschäftsführer kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung,

per Faxschreiben, E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Jeder Geschäftsführer kann seine
Zustimmung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreffenden
Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.

Art. 19. Protokoll von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer - Protokoll der Entscheidungen des alleinigen Ge-

schäftsführers.

19.1 Das Protokoll einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer wird vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer,

falls vorhanden oder, im Falle seiner Abwesenheit, vom Vorsitzenden pro tempore und dem Schriftführer (falls vorhanden)
oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche
Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kate-
gorie B), werden solche Protokolle durch einen (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einen (1) Geschäftsführer der
Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet. Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsver-
fahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer, falls
vorhanden, oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden solche Kopien oder Auszüge durch einen (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einen (1)
Geschäftsführer der Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet.

19.2 Die Entscheidungen des alleinigen Geschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom alleinigen

Geschäftsführer unterzeichnet wird. Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet.

Art. 20. Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Um-

ständen  durch  (i)  die  Unterschrift  des  alleinigen  Geschäftsführers  oder,  für  den  Fall,  dass  die  Gesellschaft  mehrere
Geschäftsführer hat, durch die gemeinsame Unterschrift zwei (2) beliebiger Geschäftsführer wirksam verpflichtet; sofern
die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer
der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B), wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift min-
destens  eines  (1)  Geschäftsführers  der  Kategorie  A  und  eines  (1)  Geschäftsführers  der  Kategorie  B  (oder  deren
Vertreter), oder (ii) durch die gemeinsamen Unterschriften oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/
denen eine Unterschriftsbefugnis durch den Rat der Geschäftsführer übertragen worden ist, wirksam verpflichtet.

E. Aufsicht und Prüfung der Gesellschaft

Art. 21. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
21.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der

Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)). Die Gesellschafterversammlung
ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.

21.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
21.3 Die Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Recht der permanenten Überprüfung und Kontrolle aller Ge-

schäfte der Gesellschaft.

141445

L

U X E M B O U R G

21.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember

2002  betreffend  das  Handelsregister  und  die  Buchhaltung  und  den  Jahresabschluss  von  Unternehmen,  in  der  jeweils
gültigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d'entreprise agréé(s)) ernennen, entfällt
die Funktion des Rechnungsprüfers.

21.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die

Gesellschafterversammlung abberufen werden.

F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinne - Abschlagsdividenden

Art. 22. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am

einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

Art. 23. Jahresabschluss und Gewinne.
23.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Rat der Geschäftsführer erstellt im

Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und
Verlustrechnung.

23.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage

der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.

23.3  Durch  einen  Gesellschafter  erbrachte  Einlagen  in  Rücklagen  können  mit  Zustimmung  dieses  Gesellschafters

ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.

23.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage entsprechend herabgesetzt

werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.

23.5 Auf Vorschlag des Rates der Geschäftsführer bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den ge-

setzlichen  Vorschriften  und  den  Bestimmungen  dieser  Satzung  wie  der  verbleibende  Bilanzgewinn  der  Gesellschaft
verwendet werden soll.

23.6 Gemäß Artikel 8, Ausschüttungen an die Gesellschafter erfolgen proportional zur Anzahl der von ihnen an der

Gesellschaft gehaltenen Anteile.

Art. 24. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
24.1 Der Rat der Geschäftsführer kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche

vom Rat der Geschäftsführer vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur
Verfügung stehen. Der ausschüttbare Betrag darf nicht die Summe der seit dem Ende des vergangenen Geschäftsjahres
angefallenen Gewinne, gegebenenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne und ausschüttbare Rücklagen, beziehungs-
weise vermindert durch vorgetragene Verluste oder Summen, die einer Rücklage zugeführt werden, welche nach dem
Gesetz von 1915 oder dieser Satzung nicht ausgeschüttert werden darf, übersteigen.

24.2 Das Agio, andere Kapitalreserven und andere ausschüttbare Rücklagen können, im Einklang mit den Bestimmungen

des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung, frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

G. Liquidation

Art. 25. Liquidation.
25.1 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Abwicklung durch

einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, die über die
Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit nichts anderes
bestimmt wird haben die Liquidatoren die weitestgehenden Rechte für die Verwertung der Vermögenswerte und die
Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

25.2 Der sich nach Verwertung der Vermögenswerte und Tilgung der Verbindlichkeiten ergebende Überschuss wird

an die Gesellschafter proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehaltenen Anteile verteilt.

H. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht

Art. 26. Anwendbares Recht. Für alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten gelten die Regelungen des

Gesetzes von 1915.

<i>Übergangsbestimmungen

1. Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember

2014.

2. Abschlagsdividenden können auch während des ersten Geschäftsjahres der Gesellschaft ausgeschüttet werden.

<i>Zeichnung und Zahlung

Die eintausendzweihundertfünfzig (1.250) ausgegebenen Stammanteile und die elftausedzweihundertfünfzig (11.250)

ausgegebenen Serie A Anteile mit jeweils einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Anteil, wurden durch Emerging

141446

L

U X E M B O U R G

Markets Online Food Delivery Holding S.à r.l., vorbenannt, zum Preis von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500)
gezeichnet.

Die Einlage für so gezeichnete Anteile wurde vollständig in bar erbracht, so dass der Gesellschaft ein Betrag in Höhe

von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) zur Verfügung steht, was dem unterzeichnenden Notar nachgewiesen
wurde.

Die gesamte Einlage von in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) wird vollständig dem Gesellschafts-

kapital zugeführt.

<i>Auslagen

Die der Gesellschaft aufgrund oder im Zusammenhang mit ihrer Gründung entstandenen Kosten, Gebühren, Honorare

und Auslagen werden auf EUR 1.500.-geschätzt.

<i>Beschlüsse des Alleingesellschafters

Der Gründungsgesellschafter, welcher das gesamte Gesellschaftskapital repräsentiert und welcher auf eine formelle

Einberufungsbekanntmachung verzichtet, hat daraufhin folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Sitz der Gesellschaft ist in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
2. Die folgenden Personen werden für unbegrenzte Zeit als Geschäftsführer der Kategorie A der Gesellschaft ernannt:
- Herr Christian Senitz, geboren am 27. Januar 1978 in Aschersleben, Deutschland, geschäftsansässig in Johannisstrasse

20, D-10117 Berlin, Deutschland.

- Herr Ralf Wenzel, geboren am 8. August 1979 in Berlin, Deutschland, geschäftsansässig in Johannisstrasse 20, D-10117

Berlin, Deutschland.

Die folgende Person wird für unbegrenzte Zeit als Geschäftsführer der Kategorie B der Gesellschaft ernannt:
- Herr Ulrich Binninger, geboren am 30. August 1966 in Trier, Deutschland, geschäftsansässig in 19, rue des Lilas,

L-8035 Strassen, Luxemburg.

Worüber, diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen wurde.
Der beurkundende Notar, welcher die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit auf Ersuchen der erschienenen

Partei, dass diese Urkunde auf Anfrage der erschienenen Partei auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen
Übersetzung. Auf Ersuchen derselben erschienenen Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen
und dem deutschen Text, soll die englische Fassung vorrangig sein.

Nachdem das Dokument dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei verlesen wurde, welche dem Notar mit Na-

men, Vornamen und Wohnsitz bekannt ist, hat der Bevollmächtigte die Urkunde zusammen mit dem Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: A. REIBOLD und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 22 août 2014. Relation: LAC/2014/39424. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - Der Gesellschaft auf Begehr erteilt.

Luxemburg, den 26. August 2014.

Référence de publication: 2014135285/637.
(140153356) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2014.

TradeRisks (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 189.765.

STATUTES

In the year two thousand and fourteen, on the fourteenth of August.
Before us Maître Henri BECK, Notary, residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1.- C.L. Nominees Limited, having its registered office at PO Box 285, 1 

st

 and 2 

nd

 Floors, Elizabeth House, Les Ruettes

Brayes, St Peter Port, Guernsey GY1 4LX, registered with the Companies' Register of Guernsey under the number 6344.

2.- Scholer Nominees Limited, having its registered office at PO Box 285, 1 

st

 and 2 

nd

 Floors, Elizabeth House, Les

Ruettes Brayes, St Peter Port, Guernsey GY1 4LX, registered with the Companies' Register of Guernsey under the
number 34269.

The appearing companies are hereby represented by Mr. Nicolas SCHREURS, private employee, residing professionally

at L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert, by virtue of two proxies given under private seal.

The said proxies, signed “ne varietur” by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned notary, will

remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

141447

L

U X E M B O U R G

The appearing parties, through their proxyholder, have requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing parties are the two sole shareholders of Landericus Fund Management (Guernsey) Limited, having its

registered office at PO Box 285, 1 

st

 and 2 

nd

 Floors, Elizabeth House, Les Ruettes Brayes, St Peter Port, Guernsey GY1

4LX, registered with the Companies' Register of Guernsey under the number 48484 (the “Company”).

II. The Company's share capital is currently set at twenty-five thousand British Pounds (GBP 25.000.-), represented

by twenty-five thousand (25.000) shares with a nominal value of one British Pound (GBP 1.-) each.

III. In accordance with the decisions made by the Company's corporate bodies on July 3, 2014 and the resolutions

adopted by the shareholders of the Company on July 4, 2014, the place of effective management and central administration
and the registered office of the Company are transferred from Guernsey to the Grand Duchy of Luxembourg with effect
as of today's date.

IV. The shareholders support and confirm as far as necessary, the decision of the Company's corporate bodies to

continue the Company as a company incorporated under the laws of Luxembourg, by transferring its registered office
and the place of effective management and central administration to the Grand Duchy of Luxembourg and consequently
adopt the Luxembourg nationality without dissolution or loss of its legal personality and without creating a new legal
entity. All necessary actions and formalities required shall be performed at the former registered office of the Company
to ensure that the transfer is performed in due form.

Such transfer does not entail dissolution or change in the legal personality of the Company and the Company will carry

on its legal existence without discontinuity, as it is evidenced by a legal opinion issued on August 7, 2014 by Carey Olsen.

V. The shareholders resolve to acknowledge the Company's interim balance sheet as of July 2, 2014, confirming that

the net asset value of the Company amounts at least to the value of the share capital (including share premium if any) of
the Company.

The shareholders record that the description and consistency of all the assets and liabilities of the Company result

from the aforementioned balance sheet.

The shareholders state that all the assets and liabilities of the Company, without limitation, remain in the ownership

of the Company, which continues to own all its assets and continues to be bound by all its liabilities and commitments.

A copy of the said balanace sheet, after being signed "ne varietur" by the proxy holder of the appearing parties and

the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

VI.  The  shareholders  resolve  that  the  Company  adopts  the  corporate  form  of  a  private  limited  liability  company

(“société à responsabilité limitée”) under the name of TradeRisks (Luxembourg) S.à r.l. and further resolved to amend
and entirely restate the articles of association of the Company, so as to conform them to Luxembourg law. These shall
henceforth have the following wording:

Art. 1. Corporate form. There exists a private limited liability company (“société à responsabilité limitée”) which will

be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the “Company”), and in particular the law dated 10 

th

August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the “Law”), as well as by the articles of association
(hereafter the “Articles”), which specify in the articles 6.1, 6.2, 6.5, 8 and 11.2 the exceptional rules applying to one
member company.

Art. 2. Corporate object.
2.1 The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign

companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or
otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other securities or interest of any kind, and the ownership, adminis-
tration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.

2.2 The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds, without a public offer, which may

be convertible and to the issuance of debentures.

2.3 In a general fashion it may grant assistance to affiliated companies, take any controlling and supervisory measures

and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

2.4 The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions

on real estate or on movable property.

Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. Denomination. The Company will have the denomination “TradeRisks (Luxembourg) S.à r.l.”.

Art. 5. Registered office.
5.1 The registered office is established in Luxembourg-City.
5.2 It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an

extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

5.3 The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the sole

manager (gérant) or in case of plurality of managers (gérants), by a decision of the board of managers (conseil de gérance).

5.4 The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

141448

L

U X E M B O U R G

Art. 6. Share Capital - Shares.
6.1 - Subscribed Share Capital
6.1.1 The Company's corporate capital is fixed at twenty-five thousand British Pounds (GBP 25.000.-), represented by

twenty-five thousand (25.000) shares (parts sociales) of one British Pound (GBP 1.-) each, all fully subscribed and entirely
paid up.

6.1.2 At the moment and as long as all the shares are held by only one shareholder, the Company is a one man company

(société unipersonnelle) in the meaning of Article 179 (2) of the Law; In this contingency Articles 200-1 and 200-2, among
others, will apply, this entailing that each decision of the single shareholder and each contract concluded between him
and the Company represented by him shall have to be established in writing.

6.2 - Modification of Share Capital
The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the general shareholders'

meeting, in accordance with Article 8 of these Articles and within the limits provided for by Article 199 of the Law.

6.3 - Profit Participation
Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number

of shares in existence.

6.4 - Indivisibility of Shares
Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Co-owners

have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.5 - Transfer of Shares
6.5.1 In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable.
6.5.2 In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred in compliance

with the requirements of Article 189 and 190 of the Law.

6.5.3 Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless shareholders representing at least three-

quarters of the corporate share capital shall have agreed thereto in a general meeting.

6.5.4 Transfers of shares must be recorded by a notarial or private deed. Transfers shall not be valid vis-à-vis the

Company or third parties until they shall have been notified to the Company or accepted by it in accordance with the
provisions of Article 1690 of the Civil Code.

6.6 - Registration of shares
All shares are in registered form, in the name of a specific person, and recorded in the shareholders' register in

accordance with Article 185 of the Law.

Art. 7. Management.
7.1 - Appointment and Removal
7.1.1 The Company is managed by a sole manager (gérant) or more managers (gérants). If several managers (gérants)

have been appointed, they will constitute a board of managers (conseil de gérance).

The members of the board of managers (conseil de gérance) might be split into two classes, respectively denominated

“class A Managers” and “class B Managers”.

The manager(s) (gérant(s)) need not to be shareholder(s).
7.1.2 The manager(s) (gérant(s)) is/are appointed by the general meeting of shareholders.
7.1.3 A manager (gérant) may be revoked ad nutum with or without cause and replaced at any time by resolution

adopted by the shareholders.

7.1.4 The sole manager (gérant) and each of the members of the board of managers (conseil de gérance) shall not be

compensated for his/their services as manager (gérant), unless otherwise resolved by the general meeting of shareholders.
The Company shall reimburse any manager (gérant) for reasonable expenses incurred in the carrying out of his office,
including  reasonable  travel  and  living  expenses  incurred  for  attending  meetings  on  the  board,  in  case  of  plurality  of
managers (gérants).

7.2 - Powers
All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the sole manager (gérant), or in case of plurality of managers (gérants), of the board of managers
(conseil de gérance).

7.3 - Representation and Signatory Power
7.3.1 In dealing with third parties as well as in justice, the sole manager (gérant), or in case of plurality of managers

(gérants), the board of managers (conseil de gérance) will have all powers to act in the name of the Company in all
circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided
the terms of this Article

7.3 shall have been complied with.

141449

L

U X E M B O U R G

7.3.2 Towards third parties, the Company shall be bound by the sole signature of its sole manager (gérant) or, in case

of plurality of managers (gérants), by the joint signature of any two managers (gérants) of the Company. In case the
managers (gérants) are split into two classes, the Company shall obligatorily be bound by the joint signature of one class
A manager (gérant de classe A) and one class B manager (gérant de classe B).

7.3.3 The sole manager (gérant), or in case of plurality of managers (gérants), the board of managers (conseil de gérance)

may sub-delegate his/its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

7.3.4 The sole manager (gérant), or in case of plurality of managers (gérants), the board of managers (conseil de gérance)

will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and
any other relevant conditions of his agency.

7.4 - Chairman, Vice-Chairman, Secretary, Procedures
7.4.1 The board of managers (conseil de gérance) may choose among its members a chairman and a vice-chairman. It

may also choose a secretary, who need not be a manager (gérant) and who shall be responsible for keeping the minutes
of the meeting of the board of managers and of the shareholders.

7.4.2 The resolutions of the board of managers (conseil de gérance) shall be recorded in the minutes, to be signed by

the chairman and the secretary, or by a notary public, and recorded in the corporate book of the Company.

7.4.3 Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed

by the chairman, by the secretary or by any manager (gérant).

7.4.4 The board of managers (conseil de gérance) can discuss or act validly only if at least a majority of the managers

(gérants) is present or represented at the meeting of the board of managers (conseil de gérance) and under the condition
that at least one class A manager and one class B manager are present or represented in case the managers (gérants) are
split into two classes.

7.4.5 In case of plurality of managers (gérants), resolutions shall be taken by a majority of the votes of the managers

(gérants) present or represented at such meeting and under the condition that at least one class A and one class B Manager
vote in favour of the resolutions in case the managers (gérants) are split into two classes.

7.4.6 Resolutions in writing approved and signed by all managers (gérants) shall have the same effect as resolutions

passed at the managers' (gérants) meetings. Such approval may be in a single or in several separate documents.

7.4.7 Any and all managers (gérants) may participate in any meeting of the board of managers (conseil de gérance) by

telephone or video conference call or by other similar means of communication allowing all the managers (gérants) taking
part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in
person at such meeting.

7.5 - Liability of Managers (gérants)
Any manager (gérant) assumes, by reason of his position, no personal liability in relation to any commitment validly

made by him in the name of the Company.

Art. 8. General shareholders' meeting.
8.1 The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders' meeting.
8.2 In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares he owns. Each shareholder shall dispose of a number of votes equal to the number of shares held by
him. Collective decisions are only validly taken insofar as shareholders owning more than half of the share capital adopt
them.

8.3 However, resolutions to alter the Articles, except in case of a change of nationality, which requires a unanimous

vote, may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarter of the Company's share
capital, subject to the provisions of the Law.

8.4 The holding of general shareholders' meetings shall not be mandatory where the number of members does not

exceed twenty-five (25). In such case, each member shall receive the precise wording of the text of the resolutions or
decisions to be adopted and shall give his vote in writing.

Art. 9. Annual General Shareholders' Meeting.
9.1 Where the number of shareholders exceeds twenty-five, an annual general meeting of shareholders shall be held,

in accordance with Article 196 of the Law at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg
as may be specified in the notice of meeting, the 1 

st

 Thursday of the month of September, at 10.00 am.

9.2 If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following

bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the sole manager
(gérant), or in case of plurality of managers (gérants), the board of managers (conseil de gérance), exceptional circums-
tances so require.

Art. 10. Audit. Where the number of shareholders exceeds twenty-five, the operations of the Company shall be

supervised by one or more statutory auditors in accordance with Article 200 of the Law who need not to be shareholder.
If there is more than one statutory auditor, the statutory auditors shall act as a collegium and form the board of auditors.

141450

L

U X E M B O U R G

Art. 11. Fiscal year - annual accounts.
11.1 - Fiscal Year
The Company's fiscal year starts on the 1 

st

 of April and ends on the 31 

st

 of March of the following year.

11.2 - Annual Accounts
11.2.1 At the end of each fiscal year, the sole manager (gérant), or in case of plurality of managers (gérants), the board

of managers (conseil de gérance) prepare an inventory, including an indication of the value of the Company's assets and
liabilities, as well as the balance sheet and the profit and loss account in which the necessary depreciation charges must
be made.

11.2.2 Each shareholder, either personally or through an appointed agent, may inspect, at the Company's registered

office, the above inventory, balance sheet, profit and loss accounts and, as the case may be, the report of the statutory
auditor(s) set-up in accordance with Article 200.

Art. 12. Distribution of profits.
12.1 The gross profit of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization

and expenses represent the net profit.

12.2 An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company shall be allocated to a statutory reserve,

until and as long as this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.

12.3 The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding

in the Company.

Art. 13. Dissolution - Liquidation.
13.1 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy

of the single shareholder or of one of the shareholders.

13.2 Except in the case of dissolution by court order, the dissolution of the Company may take place only pursuant

to a decision adopted by the general meeting of shareholders in accordance with the conditions laid down for amendments
to the Articles.

13.3 At the time of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 14. Reference to the Law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific

provision is made in these Articles.

Art. 15. Modification of articles. The Articles may be amended from time to time, and in case of plurality of shareholders,

by a meeting of shareholders, subject to the quorum and voting requirements provided by the laws of Luxembourg.

<i>Attribution of the shares

The twenty-five thousand (25.000) shares are attributed to the shareholders as follows:

1.- C.L. Nominees Limited, prenamed, twelve thousand five hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.500
2.- Scholer Nominees Limited, prenamed, twelve thousand five hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.500
Total: twenty-five thousand shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000

VII. The shareholders resolved that the first accounting year after the continuation of the Company in the Grand Duchy

of Luxembourg which began on April 1, 2014 in Guernsey, shall terminate on March 31, 2015.

VIII. The registered office of the Company is established at L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
IX. The Shareholders resolve to acknowledge the dismissal, effective as of the date of this Notarial Deed, of the current

members of the corporate bodies and to grant them full discharge for the performance of their duties.

X. The shareholders resolve, effective as of the date of this Notarial Deed, to appoint the following persons as managers

of the Company for an indefinite period:

- Mr. Barry BLACK, private employee, residing professionally at L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert,
- Mr. Nicolas SCHREURS, private employee, residing professionally at L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert,
- Mr. Alejandro Miguel PILATO, director, residing at Toseland Hall, Toseland, Cambridge, UK PE19 6RU (United

Kingdom).

<i>Ratification

The appearing parties requested the notary to act and to authenticate, in accordance with the requirements of Lu-

xembourg  Law  on  Commercial  Companies  dated  August  10 

th

  ,  1915,  the  ratification  and  confirmation,  without

qualification, nothing withheld or excepted, of all the resolutions made hereabove by the shareholders of the Company
as of the date hereof.

Consequently, the transfer of the effective management and central administration of the Company, and the esta-

blishment of the registered office of the Company at L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert, Grand Duchy of
Luxembourg are realized with effect as of today's date.

141451

L

U X E M B O U R G

The Company will thus be subject to Luxembourg law, according to article 159§2 of the Luxembourg law on Com-

mercial Companies dated August 10 

th

 , 1915.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing parties and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof, the present notarized deed was drawn up in Echternach.
The document having been read to the proxy of the appearing parties, who is known to the notary by her Surname,

Christian name, civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille quatorze, le quatorze août.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1.- C.L. Nominees Limited, ayant son siège social à PO Box 285, 1 

st

 and 2 

nd

 Floors, Elizabeth House, Les Ruettes

Brayes, St Peter Port, Guernsey GY1 4LX, inscrite au registre des sociétés de Guernsey sous le numéro 6344

2.- Scholer Nominees Limited, ayant son siège social à PO Box 285, 1 

st

 and 2nd Floors, Elizabeth House, Les Ruettes

Brayes, St Peter Port, Guernsey GY1 4LX, inscrite au registre des sociétés de Guernsey sous le numéro 34269 Les
sociétés comparantes sont ici représentées par Monsieur Nicolas SCHREURS, employé privé, demeurant professionnel-
lement à L-2543 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert, en vertu de deux procurations sous seing privé.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées «ne varietur» par le mandataire des comparants et le notaire

instrumentant, annexées aux présentes pour être enregistrées avec elles.

Lesquels comparants, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d'acter que:
I. Les comparantes sont les deux seuls associés de Landericus Fund Management (Guernsey) Limited, ayant son siège

social à PO Box 285, 1 

st

 and 2 

nd

 Floors, Elizabeth House, Les Ruettes Brayes, St Peter Port, Guernsey GY1 4LX, inscrite

au registre des sociétés de Guernsey sous le numéro 48484 (la "Société").

II. Le capital social de la Société est actuellement fixé à vingt-cinq mille Livres Sterling (GBP 25.000.-), divisé en vingt-

cinq mille (25.000) parts sociales ayant une valeur nominale d'une Livre Sterling (GPB 1.-) chacune.

III.  En  accord avec  les  décisions prises  par  les  organes  décisionnels de  la  Société en  date  du  3  juillet 2014  et les

résolutions adoptées par les associés de la Société en date du 4 juillet 2014, le siège de direction effective et d'adminis-
tration centrale ainsi que le siège social de la Société sont transférés de Guernsey au Grand-Duché de Luxembourg avec
effet à la date de ce jour.

IV. Les associés soutiennent et confirment, autant que cela est nécessaire, la décision des organes décisionnels de la

Société de poursuivre la Société en tant que société constituée selon les lois luxembourgeoises, en transférant le siège
social et le siège de direction effective et d'administration centrale au Grand-Duché de Luxembourg et en conséquence
d'adopter la nationalité luxembourgeoise sans dissolution ou perte de sa personnalité juridique et sans création d'une
nouvelle entité juridique. Toutes les actions et formalités nécessaires requises doivent être réalisées à l'ancien siège social
de la Société afin d'assurer un transfert en bonne et due forme.

Un tel transfert n'entraîne pas la dissolution ou le changement de la personnalité juridique de la Société et la Société

va poursuivre son existence juridique sans discontinuité, telle que mis en évidence dans l'opinion légale établi le 7 août
2014 par Carey Olsen.

V. Les associés décident de prendre acte du bilan intérimaire de la Société en date du 2 juillet 2014, confirmant que

la valeur nette des actifs de la Société est égale, au minimum, à la valeur du capital social (y compris la prime d'émission,
le cas échéant).

Les associés notent que la description et la consistance de l'intégralité de l'actif et du passif de la Société résultent du

bilan susmentionné.

Les associés déclarent que l'intégralité de l'actif et du passif de la Société, demeure, sans restriction, la propriété de la

société luxembourgeoise qui reste la propriétaire de tous ses actifs et continue d'être liée par tous son passif et par
l'ensemble de ses engagements.

Une copie dudit bilan, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire des comparantes et le notaire instru-

mentant, restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

VI. Les associés décident d'adopter la forme sociale d'une société à responsabilité limitée pour la Société sous le nom

de TradeRisks (Luxembourg) S.à r.l. et décident également d'amender et de refondre entièrement les statuts de la Société
afin de les mettre en conformité avec la loi Luxembourgeoise. Ces derniers doivent désormais avoir la teneur suivante:

Art. 1 

er

 . Forme sociale.  Il existe une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives (ci-après la

«Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la

141452

L

U X E M B O U R G

«Loi»”), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après les «Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 6.1, 6.2, 6.5, 8
et 11.2, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. Objet social.
2.1 L'objet de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembour-

geoises et étrangères, l'acquisition par l'achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par vente,
échange ou autre, d'actions, d'obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres titres et participations de quelque
forme que ce soit, et la propriété, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut en
outre prendre des participations dans des sociétés de personnes.

2.2 La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations qui pourront être con-

vertibles (à condition que celle-ci ne soit pas publique) et à l'émission de reconnaissances de dettes.

2.3 D'une façon générale, elle peut accorder une assistance aux sociétés affiliées, prendre toutes mesures de contrôle

et de supervision et accomplir toute opération qui pourrait être utile à l'accomplissement et au développement de son
objet.

2.4  La  Société  pourra  en  outre  effectuer  toute  opération  commerciale,  industrielle  ou  financière,  ainsi  que  toute

transaction sur des biens mobiliers ou immobiliers.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Dénomination. La Société aura la dénomination: «TradeRisks (Luxembourg) S.à r.l.».

Art. 5. Siège social.
5.1 Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
5.2 Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

5.3 L'adresse du siège social peut-être transférée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant unique ou

en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

5.4 La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 6. Capital social - parts sociales.
6.1 - Capital Souscrit et Libéré
6.1.1 Le capital social est fixé à vingt-cinq mille Livres Sterling (GBP 25.000.-), représenté par vingt-cinq mille (25.000)

parts sociales d'une valeur nominale d'une Livre Sterling (GPB 1.-) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.

6.1.2 A partir du moment et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont détenues par un seul associé, la Société

est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la Loi; Dans la mesure où les articles 200-1 et 200-2 de la
Loi trouvent à s'appliquer, chaque décision de l'associé unique et chaque contrat conclu entre lui et la Société représentée
par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit.

6.2 - Modification du Capital Social
Le capital social souscrit peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de

l'assemblée générale des associés conformément à l'article 8 des présents Statuts et dans les limites prévues à l'article
199 de la Loi.

6.3 - Participation aux Profits
Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le

nombre des parts sociales existantes.

6.4 - Indivisibilité des Parts Sociales
Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire est admis par part sociale. Les

copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.5 - Transfert de Parts Sociales
6.5.1 Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmis-

sibles.

6.5.2 Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales ne sont transmissibles que sous réserve du respect

des dispositions prévues aux articles 189 et 190 de la Loi.

6.5.3 Les parts sociales ne peuvent être transmises inter vivos à des tiers non - associés qu'après approbation préalable

en assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social.

6.5.4 Les transferts de parts sociales doivent s'effectuer par un acte notarié ou un acte sous seing privé. Les transferts

ne peuvent être opposables à l'égard de la Société ou des tiers qu'à partir du moment de leur notification à la Société ou
de leur acceptation sur base des dispositions de l'article 1690 du Code Civil.

6.6 - Enregistrement des Parts Sociales
Toutes les parts sociales sont nominatives, au nom d'une personne déterminée et sont inscrites sur le registre des

associés conformément à l'article 185 de la Loi.

141453

L

U X E M B O U R G

Art. 7. Gérance.
7.1 - Nomination et Révocation
7.1.1 La Société est gérée par un gérant unique ou par plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils consti-

tueront un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) n'est/ne sont pas nécessairement associé(s).

7.1.2 Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par l'assemblée générale des associés.
7.1.3 Un gérant pourra être révoqué ad nutum avec ou sans motif et remplacé à tout moment sur décision adoptée

par les associés.

7.1.4 Le gérant unique et chacun des membres du conseil de gérance n'est ou ne seront pas rémunéré(s) pour ses/

leurs services en tant que gérant, sauf s'il en est décidé autrement par l'assemblée générale des associés. La Société pourra
rembourser tout gérant des dépenses raisonnables survenues lors de l'exécution de son mandat, y compris les dépenses
raisonnables de voyage et de logement survenus lors de la participation à des réunions du conseil de gérance, en cas de
pluralité de gérants.

7.2 - Pouvoirs
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts à l'assemblée générale des associés

relèvent de la compétence du gérant unique ou en cas de pluralité de gérants de la compétence du conseil de gérance.

7.3 - Représentation et Signature Autorisée
7.3.1 Dans les rapports avec les tiers et avec la justice, le gérant unique, et en cas de pluralité de gérants, le conseil de

gérance aura tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations
conformément à l'objet social et sous réserve du respect des termes du présent article 7.3.

7.3.2 La Société est engagée par la seule signature du gérant unique et en cas de pluralité de gérants par la signature

conjointe de deux membres quelconques du conseil de gérance. Dans l'éventualité où deux catégories de gérants sont
créées, la Société sera obligatoirement engagée par la signature conjointe d'un gérant de classe A et d'un gérant de classe
B.

7.3.3 Le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour

des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

7.3.4 Le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera les responsabilités du

mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n'importe quelles autres
conditions pertinentes de ce mandat.

7.4 - Président, Vice-Président, Secrétaire, Procédures
7.4.1 Le conseil de gérance peut choisir parmi ses membres un président et un vice-président. Il peut aussi désigner

un secrétaire, gérant ou non, qui sera chargé de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et des
associés.

7.4.2 Les résolutions du conseil de gérance seront constatées par des procès-verbaux, qui, signés par le président et

le secrétaire ou par un notaire, seront déposées dans les livres de la Société.

7.4.3 Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourraient être produits en justice ou autrement seront signés

par le président, le secrétaire ou par un quelconque gérant.

7.4.4 Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des gérants est présente

ou représentée à la réunion du conseil de gérance, et à condition qu'au moins un gérant de classe A et un gérant de classe
B soient présents ou représentés dans l'éventualité où deux catégories de gérants sont créées.

7.4.5 En cas de pluralité de gérants, les résolutions ne pourront être prises qu'à la majorité des voix exprimées par

les gérants présents ou représentés à ladite réunion, et à condition qu'au moins un gérant de classe A et un gérant de
classe B aient voté en faveur des dites résolutions dans l'éventualité où deux catégories de gérants sont créées.

7.4.6 Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision

prise lors d'une réunion du conseil de gérance. Cette approbation peut résulter d'un seul ou de plusieurs documents
distincts.

7.4.7 Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil de gérance par “conference call”

via téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants parti-
cipant au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir
participé en personne à la réunion.

7.5 - Responsabilité des Gérants
Tout gérant ne contracte en raison de sa fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements ré-

gulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 8. Assemblée générale des associés.
8.1 L'associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés.
8.2 En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre

de parts qu'il détient. Chaque associé possède un droit de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui.

141454

L

U X E M B O U R G

Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant
plus de la moitié du capital.

8.3 Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts, sauf en cas de changement de nationalité de la Société et pour

lequel un vote à l'unanimité des associés est exigé, ne peuvent être adoptées que par une majorité d'associés détenant
au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

8.4 La tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, quand le nombre des associés n'est pas supérieur à vingt-

cinq (25). Dans ce cas, chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées
et émettra son vote par écrit.

Art. 9. Assemblée générale annuelle des associés.
9.1 Si le nombre des associés est supérieur à vingt cinq, une assemblée générale des associés doit être tenue, confor-

mément à l'article 196 de la Loi, au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg tel que précisé dans
la convocation de l'assemblée, le 1 

er

 jeudi du mois de septembre, à 10.00 heures.

9.2 Si ce jour devait être un jour non ouvrable à Luxembourg, l'assemblée générale devrait se tenir le jour ouvrable

suivant. L'assemblée générale pourra se tenir à l'étranger, si de l'avis unanime et définitif du gérant unique ou en cas de
pluralité du conseil de gérance, des circonstances exceptionnelles le requièrent.

Art. 10. Vérification des comptes. Si le nombre des associés est supérieur à vingt cinq, les opérations de la Société

sont contrôlées par un ou plusieurs commissaires aux comptes conformément à l'article 200 de la Loi, lequel ne requiert
pas qu'il(s) soi(en)t associé(s). S'il y a plus d'un commissaire, les commissaires aux comptes doivent agir en collège et
former le conseil de commissaires aux comptes.

Art. 11. Exercice social - Comptes annuels.
11.1 - Exercice Social
L'année sociale commence le premier avril et se termine le trente-et-un mars de l'année suivante.
11.2 - Comptes Annuels
11.2.1 A la fin de chaque exercice social, le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse

un inventaire (indiquant toutes les valeurs des actifs et des passifs de la Société) ainsi que le bilan, le compte de pertes et
profits, lesquels apporteront les renseignements relatifs aux charges résultant des amortissements nécessaires.

11.2.2 Chaque associé pourra personnellement ou par le biais d'un agent nommé à cet effet, examiner, au siège social

de la Société, l'inventaire susmentionné, le bilan, le compte de pertes et profits et le cas échéant le rapport du ou des
commissaire(s) établi conformément à l'article 200 de la Loi.

Art. 12. Distribution des profits.
12.1 Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements

et charges, constituent le bénéfice net.

12.2 Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à, et aussi

longtemps que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.

12.3 Le solde des bénéfices nets peut être distribué au(x) associé(s) en proportion de leur participation dans le capital

de la Société.

Art. 13. Dissolution - Liquidation.
13.1 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la

faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

13.2 Sauf dans le cas d'une dissolution par décision judiciaire, la dissolution de la Société ne peut se faire que sur

décision adoptée par l'assemblée générale des associés dans les conditions exigées pour la modification des Statuts.

13.3 Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, associés

ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunération.

Art. 14. Référence à la Loi. Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, il est fait référence

aux dispositions de la Loi.

Art. 15. Modification des statuts. Les présents Statuts pourront être à tout moment modifiés par l'assemblée des

associés selon le quorum et conditions de vote requis par les lois du Grand - Duché de Luxembourg.

<i>Attribution des parts sociales

Les vingt-cinq mille (25.000) parts sociales sont attribuées aux associés comme suit:

1.- C.L. Nominees Limited, préqualifiée, douze mille cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.500
2.- Scholer Nominees Limited, préqualifiée, douze mille cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.500
Total: vingt-cinq mille parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000

VII.  Les  associés  décident  que  le  premier  exercice  social  après  la  continuation  de  la  Société  au  Grand-Duché  de

Luxembourg qui a commencé le 1 

er

 avril 2014 à Guernsey, doit se terminer le 31 mars 2015.

141455

L

U X E M B O U R G

VIII. Le siège social de la Société est établi à L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert, avec effet immédiat.
IX. Les associés décident de prendre acte du renvoi, effectif à la date du présent Acte Notarié, des membres actuels

des organes décisionnels de la Société et de leur accorder pleine décharge pour l'exécution de leurs foncions.

X. Les associés décident de nommer les personnes suivantes, avec effet immédiat, en qualité de nouveaux gérants de

la Société pour une durée indéterminée:

- Monsieur Barry BLACK, employé privé, demeurant professionnellement à L-2543 Luxembourg, 19, rue Eugène Rup-

pert,

- Monsieur Nicolas SCHREURS, employé privé, demeurant professionnellement à L-2543 Luxembourg, 19, rue Eugène

Ruppert,

- Monsieur Alejandro Miguel PILATO, directeur, demeurant à Toseland Hall, Toseland, Cambridge, UK PE19 6RU

(Royaume-Uni).

<i>Ratification

Les comparants ont requis le notaire d'acter et d'authentifier, conformément aux prescriptions de la loi luxembour-

geoise sur les sociétés commerciales en date du 10 août 1915, la ratification et la confirmation, sans réserves, exclusions
ou exceptions, de toutes les résolutions prises ci-dessus par les associés de la Société en ce jour.

En conséquence, le transfert du siège de direction effective et d'administration centrale, et l'établissement du siège

social de la Société à L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert, Grand-Duché de Luxembourg sont réalisés avec effet
à la présente date.

La Société sera en conséquence soumise à la loi luxembourgeoise, en application de l'article 159§2 de la loi luxem-

bourgeoise sur les sociétés commerciales en date du 10 août 1915.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête des mêmes comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version

anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Echternach, date qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, connue du notaire par son nom et prénom, état

et demeure, elle a signé ensemble avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: N. SCHREURS, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 18 août 2014. Relation: ECH/2014/1555. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur ff.

 (signé): D. SPELLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 26 août 2014.

Référence de publication: 2014135227/493.
(140153329) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2014.

YGIP-ASIA PAC S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 158.765.

<i>Extrait des résolutions prises à l'associé unique de la société tenue en date du 06 août 2014

Le mandat des gérants:
1. Monsieur Stephen LAWRENCE, demeurant professionnellement à 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, gé-

rant;

2. Monsieur Alastair SIMPSON, demeurant professionnellement à 25, Sackville Street, Londres W1S 3AX, Royaume-

Uni, gérant;

est renouvelé jusqu'à l'issue de la prochaine l'associé unique de la Société statuant sur les comptes clos en décembre

2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Référence de publication: 2014135876/18.
(140153964) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2014.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

141456


Document Outline

20140726 Holding S.à r.l.

FVD House S.A.

GC Extreme S.à r.l.

Kara Finance SPF S.A.

Karel S.à r.l.

Keasy

Keasy

Knauf Luxembourg S.à r.l.

Koromandel Invest S.A.

Krabi International S.A.

Lapi Investments S.A.

LDV Management II Meigerhorn II S.C.A.

Likipi Holding S.A.

Lodging Products &amp; Services S.à r.l.

LOGOS IT Services S.A.

Madinina S.A.

Mail Order World S.A.

Maisons du Monde Luxembourg, S.à r.l.

Malva S.à r.l.

Mavilla Immobilière S.à r.l.

MBNA R&amp;L S.à r.l.

Mc. Innovation S.à r.l.

Midas Holdco IV S.à r.l.

Muller &amp; Associés S.A.

Naturfleesch S.à r.l.

New Blitz

New Energy Above Training

Octopus Development S.A.

Open V-IT Sàrl

Pegasus Holdings (Belgium) S.à r.l.

Pine River Fixed Income Lux Investments S.à r.l.

Platinum UCITS Funds SICAV

Praxair Holding Latinoamérica

Re Schools S.à r.l.

Roda S.à r.l.

RSM Cosal

Satofi S.A.

Sephir Participation S.à r.l.

SG Audit S.àr.l.

Silver Star S.A.

Simius Promotions S.àr.l.

Société Financière du Méditerranéen S.A., SPF

Société Financière du Méditerranéen S.A., SPF

Sonnenhof S.A. SPF

Soparfi Codes Holding S.A.

St Charles Luxembourg S.A.

Stonegate Pub Company Group S.à r.l.

Swedbank Management Company S.A.

TCW/MAC Capital Ltd. Luxembourg S.à r.l.

Timea Properties S.à r.l.

Timone GP

Toiture Moderne N.E. Sàrl

TradeRisks (Luxembourg) S.à r.l.

TRALUX, Société Générale de Travaux - Luxembourg S.à r.l.

UrbaniaBT1 S.à r.l.

VH In Solutions S.A.

VLW Lion S.A.

YGIP-ASIA PAC S.à r.l.