This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2943
15 octobre 2014
SOMMAIRE
Aardvark Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . .
141254
Aardvark Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . .
141264
Active Solutions S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
141254
AKT Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
141222
Altra Partners S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141226
APEX Technologies S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
141221
Arianne Properties S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
141257
Artek SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141221
ATEEL - Allied Technology Experts Enter-
prise of Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
141223
Auberge de l'Our . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141218
Balspeed Re S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141222
Bautrafix S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141222
B.C.I. Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141221
Bestebreurtje S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141225
Biname Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
141224
Bleu Book Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141264
Borletti Group High Retail S.C.A. . . . . . . .
141224
Borletti Group High S.C.A. . . . . . . . . . . . . .
141225
Cambenes S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141223
Cam Luxembourg G.m.b.h. . . . . . . . . . . . . .
141263
Casa-Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141264
Chaud-Froid S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141221
C&J Luxembourg G.m.b.H. . . . . . . . . . . . . .
141263
Compagnie Investissement Europe Hold-
ing Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141225
Cor International S.à r.l. Soparfi . . . . . . . . .
141227
Crown Premium Private Equity VI Master
S.C.S,SICAV-FIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141245
Dal Futura S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141252
DGAD International S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . .
141222
Dolce Vita S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141223
Domus International S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
141224
Doppler Tim GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141224
ECH S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141223
Filomena S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141247
Forticrus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141225
Gavento S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141249
Halltex Luxemburg G.m.b.H. . . . . . . . . . . .
141228
HW Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141253
International Shipowners Reinsurance
Company S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141248
KDC Investments,Luxembourg Branch . .
141230
Lehnkering Shipping Lux S.A. . . . . . . . . . . .
141220
Lovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141219
Minett Private S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141219
Minett Private S.A. SPF . . . . . . . . . . . . . . . . .
141219
MOLLING Patrick Agence, S. à r.l. . . . . . .
141219
NCR International & Co Luxembourg Hol-
dings SNC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141218
New Hope Investments S.à r.l. . . . . . . . . . .
141219
Northam CCPF II PropCo BTS (J) S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141226
Norwin Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141220
Oceana Hold Co. II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
141220
Oceana Hold Co. I S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
141219
Oktav RE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141226
Omnifone S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141220
Private VCL S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141220
ProLogis France XXXV S.àr.l. . . . . . . . . . . .
141218
Redcor Reaseguros S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
141250
Sodium Investment S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
141225
Temrex S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141246
Tevaco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141229
The Taplow Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
141223
Twist Beauty International Holdings S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141218
Utilis International S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
141224
Westbridge S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141221
XXL All Sports United S.à r.l. . . . . . . . . . . .
141263
141217
L
U X E M B O U R G
Twist Beauty International Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 170.491.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 août 2014.
Référence de publication: 2014132821/10.
(140149991) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2014.
ProLogis France XXXV S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 83.485.
à modifier: Suite à un contrat daté du 19 Août 2014, une (1) part sociale détenue dans la Société par, ProLogis European
Holdings XVII Sàrl a été transférée à ProLogis European Finance XVII Sàrl ayant son siège social à 34-38 Avenue de la
Liberté, L-1930 Luxembourg. Cette cession des part sociale a été approuvée au nom et pour compte de la Société par
un de ses gérants.
A faire paraître dans l'Extrait:
Répartitions des parts sociales:
ProLogis European Finance XVII Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 parts
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 parts sociales
Luxembourg, le 21 août 2014.
ProLogis Directorship Sàrl
<i>Gérant
i>Représenté par Gerrit Jan Meerkerk
<i>Géranti>
Référence de publication: 2014132709/20.
(140150687) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2014.
Auberge de l'Our, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 8A, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 93.352.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014132948/9.
(140151416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2014.
NCR International & Co Luxembourg Holdings SNC, Société en nom collectif.
Capital social: USD 10.000,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 171.406.
Il résulte d'un acte daté du 10 mars 2014, que l'associé «Radiant Systems International, Inc», a changé sa dénomination
en «NCR International, Inc».
Il résulte également de cet acte que le gérant de la Société, «Radiant Systems International, Inc», a changé sa dénomi-
nation en «NCR International, Inc».
Munsbach, le 21 Août 2014.
<i>Pour la Société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2014133274/15.
(140151282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2014.
141218
L
U X E M B O U R G
New Hope Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 145.018.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 août 2014.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2014133263/12.
(140151194) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2014.
MOLLING Patrick Agence, S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7253 Walferdange, 6, Iwwert dem Geierpad.
R.C.S. Luxembourg B 118.726.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014133260/9.
(140151162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2014.
Minett Private S.A., Société Anonyme Soparfi,
(anc. Minett Private S.A. SPF).
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 169.181.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 22 août 2014.
Référence de publication: 2014133255/10.
(140150972) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2014.
Lovi, Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 124.606.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
Un administrateuri>
Référence de publication: 2014133224/11.
(140151256) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2014.
Oceana Hold Co. I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 158.243.
Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 Décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 Août 2014.
Oceana Hold Co I S.à r.l.
Référence de publication: 2014133281/12.
(140150863) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2014.
141219
L
U X E M B O U R G
Oceana Hold Co. II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 158.290.
Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 Décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 Août 2014.
Oceana Hold Co II S.à r.l.
Référence de publication: 2014133282/12.
(140150872) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2014.
Omnifone S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 155.735.
RECTIFICATIF
Les comptes annuels au 30 avril 2012 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg le 26 mars
2013 référencés L130049120 sont dès lors rectifiés par les présents comptes annuels.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
OMNIFONE S.A.R.L.
Référence de publication: 2014133283/12.
(140150825) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2014.
Norwin Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 97.446.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
NORWIN GROUP S.A.
Référence de publication: 2014133278/10.
(140150954) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2014.
Lehnkering Shipping Lux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6637 Wasserbillig, 37, esplanade de la Moselle.
R.C.S. Luxembourg B 67.246.
Les comptes annuels au 30 juin 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014133215/10.
(140150823) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2014.
Private VCL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 142.646.
Le Bilan du 1
er
Janvier 2013 au 31 Décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014133315/10.
(140151399) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2014.
141220
L
U X E M B O U R G
Westbridge S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 100.000,00.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 98.280.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 août 2014.
Référence de publication: 2014132852/10.
(140150133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2014.
B.C.I. Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5421 Erpeldange, 13, rue de Rolling.
R.C.S. Luxembourg B 118.087.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 22 août 2014.
Référence de publication: 2014132951/10.
(140151362) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2014.
Chaud-Froid S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2667 Luxembourg, 35-37, rue Verte.
R.C.S. Luxembourg B 45.856.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 22 août 2014.
Signature.
Référence de publication: 2014133019/10.
(140151044) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2014.
APEX Technologies S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 62.496.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22/08/2014.
G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg
Référence de publication: 2014132941/12.
(140151273) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2014.
Artek SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 4, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 129.305.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 01/07/2014.
Alexandre Rosenberg
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2014132945/12.
(140150887) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2014.
141221
L
U X E M B O U R G
AKT Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 198.691,00.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 138.485.
Les comptes annuels de la société au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2014132933/12.
(140151263) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2014.
Bautrafix S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9147 Erpeldange, 1A, rue du Viaduc.
R.C.S. Luxembourg B 93.381.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 22 août 2014.
Référence de publication: 2014132968/10.
(140151361) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2014.
DGAD International S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 31-33, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 120.636.
Le Bilan au 31.12.2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014133040/10.
(140151024) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2014.
Balspeed Re S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 34.186.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue le 21 août 2014i>
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée décide de renouveler le mandat des Administrateurs.
Ces mandats viendront à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exer-
cice social 2014.
<i>Cinquième résolutioni>
L'Assemblée décide, conformément aux dispositions de l'article 100 de la loi modifiée du 6 décembre 1991, de nommer
Réviseur Indépendant de la société:
ATWELL
17, rue des Jardiniers
L-1835 Luxembourg
dont le mandat viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice
social 2014.
<i>Pour la société BALSPEED RE S.A.
i>AON Insurance Managers (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2014132960/22.
(140151113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2014.
141222
L
U X E M B O U R G
The Taplow Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 101.567.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Référence de publication: 2014132825/10.
(140150068) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2014.
Cambenes S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 106.241.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 19 août 2014.
Référence de publication: 2014133008/10.
(140151146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2014.
Dolce Vita S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5630 Mondorf-les-Bains, 4, avenue Dr Klein.
R.C.S. Luxembourg B 33.809.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 22 août 2014.
Référence de publication: 2014133044/10.
(140151358) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2014.
ECH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 109.467.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 août 2014.
Référence de publication: 2014133057/10.
(140151426) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2014.
ATEEL - Allied Technology Experts Enterprise of Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6871 Wecker, 14, op Huefdreisch.
R.C.S. Luxembourg B 138.685.
La dénomination de l'associé unique de la société à responsabilité limitée ATEEL - Allied Technology Experts Enterprise
of Luxembourg S.à r.l. a changé, la nouvelle dénomination étant GTÜ ATEEL AG enregistrée sous le numéro B 172819
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22.08.2014.
G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg
Référence de publication: 2014132946/14.
(140150998) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2014.
141223
L
U X E M B O U R G
Borletti Group High Retail S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 140.161.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale tenue le 18/08/2014.i>
<i>Résolution:i>
L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat venant à échéance de H.R.T. Révision S.A., réviseur d'entre-
prises, jusqu'à l'Assemblée qui se tiendra en 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 18/08/2014.
Référence de publication: 2014132955/14.
(140150811) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2014.
Utilis International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3333 Hellange, 28, route de Bettembourg.
R.C.S. Luxembourg B 98.780.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 août 2014.
Référence de publication: 2014132836/10.
(140150265) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2014.
Biname Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon Ier.
R.C.S. Luxembourg B 118.452.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014132976/9.
(140151052) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2014.
Domus International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 106.877.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 22 août 2014i>
1. Monsieur Claude Schroeder, demeurant professionnellement au 498, Route de Thionville, L-5886 Alzingen a été
nommé administrateur jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2019 en remplacement de Monsieur Herbert
Grossmann décédé le 17 juin 2014.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2014133045/12.
(140151079) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2014.
Doppler Tim GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5326 Contern, 5, rue de l'Etang.
R.C.S. Luxembourg B 163.641.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014133046/9.
(140151382) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2014.
141224
L
U X E M B O U R G
Borletti Group High S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 136.522.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 18/08/2014.i>
<i>Résolution:i>
Le mandat du réviseur d'entreprises agréé venant à échéance, l'assemblée générale décide de renouveler le mandat
de HRT Révision jusqu'à l'assemblée à être tenue en 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 18/08/2014.
Référence de publication: 2014132956/14.
(140150812) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2014.
Sodium Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 185.953.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 août 2014.
Référence de publication: 2014132842/10.
(140150733) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2014.
Forticrus, Société Anonyme.
Siège social: L-6783 Grevenmacher, 31, Op der Heckmill.
R.C.S. Luxembourg B 170.958.
<i>Auszug aus der Beschlussfassung des Verwaltungsrates vom 13. August 2012i>
- Herr Peter Ewen ist gemäß Artikel 9 der Gesellschaftssatzung zum Bevollmächtigten des Verwaltungsrates zu ernannt.
Gemäß Artikel 10 der Gesellschaftssatzung hat er somit die Befugnis, die Gesellschaft durch Einzelunterschrift rechtsgültig
zu vertreten.
<i>Der Verwaltungsrati>
Référence de publication: 2014133101/12.
(140151226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2014.
Bestebreurtje S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.
R.C.S. Luxembourg B 36.108.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014132974/9.
(140150957) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2014.
Compagnie Investissement Europe Holding Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 32.283.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014133028/9.
(140151033) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2014.
141225
L
U X E M B O U R G
Altra Partners S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 151.538.
La démission de Monsieur MACDONALD Willis Niall est acceptée. En remplacement est nommé au poste d'admi-
nistrateur Monsieur Sassan GOLSHANI né le 10/06/1976 à Téhéran demeurant à GB-SW74QB Londres, 13G, Brechin
Place.
Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur à savoir à l'issue de l'assemblée générale ordinaire
qui se tiendra en l'an 2015.
Luxembourg, le 20/06/2014.
Référence de publication: 2014132935/13.
(140150942) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2014.
Northam CCPF II PropCo BTS (J) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: CAD 25.000,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillauem Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 169.462.
Les comptes annuels pour la période du 8 juin 2012 (date de constitution) au 31 décembre 2012 ont été déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 août 2014.
Référence de publication: 2014133268/11.
(140151109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2014.
Oktav RE, Société Anonyme de Titrisation.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.
R.C.S. Luxembourg B 181.771.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg en date du 20 août 2014i>
L'Assemblée générale a pris la résolution suivante:
- L'Assemblée générale a décidé d'accepter la démission de:
* Mme Emilie Bensmihen, née le 5 mai 1981 à Schiltigheim (France), résidant professionnellement au 3, rue des Bains,
L-1212 Luxembourg, en qualité d'administrateur avec effet au 19 Août 2014;
* Mme Véronique De Meester, née le 24 mai 1955 à Ixelles (Belgique), résidant professionnellement au 3, rue des
Bains, L-1212 Luxembourg, en qualité d'administrateur avec effet au 19 Août 2014;
* M. Sylvain Elias, né le 2 novembre 1981 à Etterbreek (Belgique), résidant professionnellement au 3, rue des Bains,
L-1212 Luxembourg, en qualité d'administrateur avec effet au 19 Août 2014;
- L'Assemblée générale a décidé décide de nominer:
* M. Thierry Grosjean, né le 03 août 1974 à Metz (France), résidant professionnellement au 15, rue Léon Laval, L-3372
Leudelange, en qualité d'administrateur avec effet au 19 Août 2014;
* Mme Claudia Schweich, née le 1
er
août 1979 à Arlon (Belgique), résidant professionnellement au 15, rue Léon Laval,
L-3372 Leudelange, en qualité d'administrateur avec effet au 19 Août 2014;
* Mme Dorothée Ciolino, née le 04 juin 1973 à Epinal (France), résidant au 21, route d'arlon, L-1140 Luxembourg,,
en qualité d'administrateur avec effet au 19 Août 2014;
Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui approuvera les comptes annuels au 31
décembre 2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 Août 2014.
<i>Pour Oktav RE S.A.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2014132018/30.
(140149441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2014.
141226
L
U X E M B O U R G
Cor International S.à r.l. Soparfi, Société à responsabilité limitée soparfi.
Siège social: L-5570 Remich, 35, route de Stadtbredimus.
R.C.S. Luxembourg B 189.663.
STATUTEN
Im Jahre zweitausendvierzehn, am ersten August.
Vor Uns Notar Roger ARRENSDORFF, im Amtssitz zu Luxemburg (Großherzogtum Luxembourg).
Sind erschienen:
1) Edgar WIERSCHEN, Kaufmann, beruflich wohnhaft in L-5570 Remich, 35, route de Stadtbredimus.
2) Roland MONSELER, Bankkaufmann, beruflich wohnhaft in L-5570 Remich, 35, route de Stadtbredimus.
Welche Komparenten den unterzeichneten Notar ersuchten, die Satzung einer von ihnen zu grundenden Gesellschaft
mit beschrankter Haftung nach luxemburgischem Recht wie folgt zu beurkunden:
Art. 1. Die Gesellschaftsbezeichnung lautet: "Cor International S.àr.l. Soparfi".
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Remich.
Art. 3. Die Gesellschaft hat zum Zweck die Abwicklung von kommerziellen, industriellen und finanziellen Geschäften,
unter welcher Form auch immer, aller Geschäfte welche sich auf Mobiliar- und Immobiliarwerte beziehen sowie die
Beteiligung an anderen Gesellschaften.
Desweiteren kann sie Gesellschaften an denen sie beteiligt ist, jede Art von Unterstützung gewähren, sei es durch
Darlehen, Garantien und Vorschüsse.
Die Gesellschaft kann alle Arten von Wertpapieren und Rechten erwerben, dieselben verwalten und verwerten.
Die Gesellschaft kann generell alle Tätigkeiten und Geschäfte betreiben welche mittelbar oder unmittelbar mit ihrem
Gesellschaftszweck zusammenhängen.
Art. 4. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.
Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt ZWÖLFTAUSEND FÜNFHUNDERT EURO (12.500,-€) und ist in ZWEI-
HUNDERTFÜNFZIG (250) Anteile von je FÜNFZIG EURO (50,-€) eingeteilt.
Art. 6. Unter Gesellschaftern sind die Anteile frei abtretbar.
Sie können nur unter Lebenden oder von Todes wegen an Nichtgesellschafter abgetreten werden gemäss den Bes-
timmungen von Art. 189 von dem koordinierten Text des Gesetzes vom 10. August 1915 und der diesbezüglichen
Abänderungsgesetze.
Art. 7. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer verwaltet, deren Zahl, Amtsdauer und Be-
fugnisse durch die Generalversammlung festgesetzt werden und die zu jeder Zeit durch letztere abberufen werden
können, ohne Angabe von Gründen.
Art. 8. Das Gesellschaftsjahr beginnt am ersten Januar und endigt am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.
Art. 9. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Komparenten auf die gesetzlichen
Bestimmungen.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt ausnahmsweise heute und endet am 31. Dezember 2014
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Das Gesellschaftskapital wurde wie folgt gezeichnet und zugeteilt:
1) Edgar WIERSCHEN, einhundertfünfundzwanzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
2) Roland MONSELER, einhundertfünfundzwanzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Total: Zweihundertfünfzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Alle Anteile wurden vollständig und in bar eingezahlt, so daß der Betrag von ZWÖLFTAUSENDFÜNFHUNDERT
EURO (12.500.- €) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht.
<i>Generalversammlungi>
Sodann vereinigen die Gesellschafter sich in einer ausserordentlichen Generalversammlung zu welcher sie sich als
gehörig und richtig einberufen erklären und nehmen folgende Beschlüsse:
1) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-5570 Remich, 35, route de Stadtbredimus.
2) Die Zahl der Geschäftsführer wird festgelegt auf zwei (2).
Werden zum Geschäftsführern ernannt:
141227
L
U X E M B O U R G
1) Edgar WIERSCHEN, Kaufmann, beruflich wohnhaft in L-5570 Remich, 35, route de Stadtbredimus.
2) Roland MONSELER, Bankkaufmann, beruflich wohnhaft in L-5570 Remich, 35, route de Stadtbredimus.
Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber verpflichtet durch die jeweilige Einzelunterschrift eines jeden Geschäftsfüh-
rers.
Vor Abschluß der gegenwärtigen Urkunde hat der unterzeichnete Notar die Komparenten auf die Notwendigkeit
hingewiesen, die behördlichen Genehmigungen zu erhalten zwecks Ausübung des Gesellschaftsgegenstandes
Worüber Urkunde, Errichtet wurde zu Luxemburg in der Amtsstube.
Nach Vorlesung an die Komparenten, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: WIERSCHEN, MONSELER, ARRENSDORFF.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 01 août 2014. Relation: LAC / 2014 / 36630. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i>
(signé): FRISING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.
Luxembourg, le 22 août 2014.
Référence de publication: 2014133002/67.
(140150945) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2014.
Halltex Luxemburg G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8450 Steinfort, 21, Cité de l'Usine.
R.C.S. Luxembourg B 113.205.
Im Jahre zweitausendvierzehn, am neunzehnten Tag des Monats August.
Vor dem unterzeichneten Notar Edouard DELOSCH mit Amtswohnsitz in Diekirch.
Ist erschienen:
Herr Joseph DHAMEN, Rentner, geboren am 29. September 1942 in Hobscheid (Luxemburg), wohnhaft in L-8450
Steinfort, 21, Cité de l'Usine.
Welcher Komparent den unterzeichneten Notar ersuchte, Nachfolgendes zu beurkunden:
I.- Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung „Halltex Luxemburg G.m.b.h.“, mit Sitz in L-8450 Steinfort, 21 Cité de
l'Usine, wurde gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch den Notar Jean Seckler, mit Amtssitz in Junglinster,
Grossherzogtum Luxemburg, am 29. November 2005, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
Nummer 691, vom 5. April 2006, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter Sektion B und
Nummer 113 205. Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt abgeändert gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar
Blanche MOUTRIER, mit damaligen Amtssitz in Esch-sur-Alzette, am 3. März 2010, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, Nummer 796, vom 17. April 2010.
II.- Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), eingeteilt in einhundert (100) Anteile
von jeweils einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-), alle den Herrn Joseph DHAMEN, vorbenannt, Somit ist das
gesamte Kapital hier vertreten.
III. Die Tagesordnung lautet wie folgt:
<i>Tagesordnungi>
1. Vorzeitige Auflösung der Gesellschaft „Halltex Luxemburg G.m.b.h.“ und ihre Liquidation.
2. Ernennung von Herrn Joseph DHAMEN als Liquidator der Gesellschaft, und Festlegung von seinen Befugnissen;
3. Verschiedenes.
IV. Alsdann ersuchen der einzige Gesellschafter den amtierenden Notar nachfolgende Beschlüsse zu beurkunden:
<i>Erster Beschlussi>
Der alleinige Gesellschafter beschließt die vorzeitige Auflösung der Gesellschaft „Halltex Luxemburg G.m.b.h.“ und
ihre Liquidation.
<i>Zweiter Beschlussi>
Der alleinige Gesellschafter beschließt, Herrn Joseph DHAMEN, vorbenannt, zum Liquidator der Gesellschaft zu er-
nennen.
Der Liquidator verfügt über die weitgehendsten durch das Gesetz, und namentlich durch die Artikel 144 bis 148 des
abgeänderten Luxemburgischen Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, vorgesehenen Befugnisse
und Vollmachten, sogar ohne vorherige Ermächtigung durch die Generalversammlung im Falle wo diese Ermächtigung
normalerweise erforderlich wäre.
141228
L
U X E M B O U R G
<i>Kostenabschätzungi>
Die der Gesellschaft aus Anlass vorliegender Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf unge-
fähr Eintausend Euros (EUR 1.000,-) geschätzt.
Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Diekirch, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an der Komparent, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem
Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben er selbst mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: J. DHAMEN, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch le 20 août 2014. Relation: DIE/2014/10469. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveur ff.i> (signé): RIES.
Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Begehr erteilt.
Diekirch, den 21. August 2014.
Référence de publication: 2014133130/50.
(140150951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2014.
Tevaco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1143 Luxembourg, 15, rue Astrid.
R.C.S. Luxembourg B 89.289.
L'an deux mille quatorze, le vingt-neuf juillet.
Par-devant Nous, Maître Jean-Paul MEYERS, notaire, de résidence à Rambrouch (Grand-Duché de Luxembourg), agis-
sant en remplacement de Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg),
lequel dernier nommé restera dépositaire de la présente minute.
A comparu:
«EXETER», société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 9, rue Théodule Ribot, F-75017 Paris (France),
ici représentée par Madame Johanna SCHADECK, expert-comptable, avec adresse professionnelle au 15, rue Astrid,
L-1143 Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée à Paris le 20 juillet 2014, laquelle procuration, après avoir été
signée "ne varietur" par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour
être enregistrée en même temps.
Laquelle comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant d'acter que:
I. La comparante est la seule associée («l’Associée Unique») de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg
sous la dénomination de «TEVACO S.à r.l.» (la «Société»), ayant son siège social au 15, rue Astrid, L-1143 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
89.289, constituée suivant acte notarié en date du 26 septembre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 1632 en date du 14 novembre 2002, dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu par acte passé
par-Maître Jean-Joseph WAGNER, prénommé, en date du 28 novembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 537 en date du 14 mars 2006.
II. Le capital social de la Société est de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents (500)
parts sociales, d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.
III. La comparante a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit les résolutions ci-après:
<i>Première résolutioni>
L’Associée Unique décide de modifier l’objet social de la Société par l’ajout d’un alinéa à l’article 2 des statuts de la
Société lui permettant d’assurer la fonction d’agent calculateur pour toutes sociétés du groupe ou pour toutes autres
sociétés, luxembourgeoises ou étrangères, incluant les sociétés de titrisation. Par conséquent, l’article 2 des statuts de la
Société aura désormais la teneur suivante:
« Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l’aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la
gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient
une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.
La Société pourra également assurer la fonction d’agent calculateur pour toutes sociétés qui font partie du même
groupe de sociétés que la Société et pour toutes autres sociétés, luxembourgeoises ou étrangères, incluant les sociétés
de titrisation.
La Société pourra exercer toute activité de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l’ac-
complissement de son objet.»
141229
L
U X E M B O U R G
<i>Deuxième résolutioni>
L’Associée Unique décide de modifier l’article douze (12) des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur
suivante:
« Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n’ont pas besoin d’être associés.
Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par l’assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur mandat.
En cas de pluralité gérants, la Société est administrée par un conseil de gérance, associés ou non.
Les gérants sont librement et à tout moment révocables.
Le conseil de gérance peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous sein privé.
La Société est engagée par la signature conjointe de deux (2) gérants ou par la signature conjointe ou unique de toutes
personnes auxquelles un tel pouvoir de signature aura été délégué par le conseil de gérance. Toutefois, pour toutes les
opérations entrant dans le cadre des activités soumises à l’autorisation préalable du Ministère des Classes Moyennes, la
Société devra toujours être engagée par la signature conjointe d’un gérant et de la personne au nom de laquelle ladite
autorisation est délivrée.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, la comparante susmentionnée a signé avec le notaire instru-
mentant le présent procès-verbal.
Signé: J. SCHADECK, J.P. MEYERS.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 6 août 2014. Relation: EAC/2014/10856. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Monique HALSDORF.
Référence de publication: 2014132823/64.
(140150218) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2014.
KDC Investments,Luxembourg Branch, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 189.756.
STATUTES
1. The name of the Company is 3147014 Nova Scotia Company,
2. There are no restrictions on the objects and powers of the Company and the Company shall expressly have the
following powers:
(1) to sell or dispose of its undertaking, or a substantial part thereof;
(2) to distribute any of its property in specie among its members; and
(3) to amalgamate with any company or other body of persons.
3. The liability of the members is unlimited.
I, the undersigned, whose name, address and occupation are subscribed, am desirous of being formed into a company
in pursuance of this Memorandum of Association, and I agree to take the number and kind of shares in the capital stock
of the Company written below my name.
Name of Subscriber: Charles S. Reagh
900-1959 Upper Water Street, Halifax, NS B3J 2X2
Occupation: Solicitor
Number of shares subscribed: One common share
TOTAL SHARES TAKEN: One common share
Witness to above signature:
Dated this 22
nd
day of September, 2006.
900-1959 Upper Water Street, Halifax, NS B3J 2X2
Amy Smith
<i>Legal Assistanti>
ARTICLES OF ASSOCIATION
OF
3147014 NOVA SCOTIA COMPANY
Interpretation
1. In these Articles, unless there be something in the subject or context inconsistent therewith:
141230
L
U X E M B O U R G
(1) "Act" means the Companies Act (Nova Scotia);
(2) "Articles" means these Articles of Association of the Company and all amendments hereto;
(3) "Company" means the company named above;
(4) "director" means a director of the Company;
(5) "Memorandum" means the Memorandum of Association of the Company and all amendments thereto;
(6) "month" means calendar month;
(7) "Office" means the registered office of the Company;
(8) "person" includes a body corporate;
(9) "proxyholder" includes an alternate proxyholder;
(10) "Register" means the register of members kept pursuant to the Act, and where the context permits includes a
branch register of members;
(11) "Registrar" means the Registrar as defined in the Act;
(12) "Secretary" includes any person appointed to perform the duties of the Secretary temporarily;
(13) "shareholder" means member as that term is used in the Act in connection with an unlimited company having
share capital and as that term is used in the Memorandum;
(14) "special resolution" has the meaning assigned by the Act;
(15) "in writing" and "written" includes printing, lithography and other modes of representing or reproducing words
in visible form;
(16) words importing number or gender include all numbers and genders unless the context otherwise requires.
2. The regulations in Table A in the First Schedule to the Act shall not apply to the Company.
3. The directors may enter into and carry into effect or adopt and carry into effect any agreement made by the
promoters of the Company on behalf of the Company and may agree to any modification in the terms of any such
agreement, either before or after its execution.
4. The directors may, out of the funds of the Company, pay all expenses incurred for the incorporation and organization
of the Company.
5. The Company may commence business on the day following incorporation or so soon -thereafter as the directors
to-allotted.
Shares
6. The capital of the company shall consist of 500,000,000 common shares without nominal or par value and
500,000,000 preferred shares without nominal or par value, each having the rights, restrictions, conditions and limitation
set out in Annex 1 hereto and with the power to divide the shares in the capital for the time being into classes or series
and to attach thereto respectively any preferred, deferred or qualified rights, privileges or conditions, including restrictions
on voting rights and including redemption, purchase and other acquisition of such shares, subject, however, to the pro-
visions of the Act.
7. The directors shall control the shares and, subject to the provisions of these Articles, may allot or otherwise dispose
of them to such person at such times, on such terms and conditions and, if the shares have a par value, either at a premium
or at par, as they think fit.
8. The directors may pay on behalf of the Company a reasonable commission to any person in consideration of
subscribing or agreeing to subscribe (whether absolutely or conditionally) for any shares in the Company, or procuring
or agreeing to procure subscriptions (whether absolute or conditional) for any shares in the Company. Subject to the
Act, the commission may be paid or satisfied in shares of the Company.
9. On the issue of shares the Company may arrange among the holders thereof differences in the calls to be paid and
in the times for their payment.
10. If the whole or part of the allotment price of any shares is, by the conditions of their allotment, payable in instal-
ments, every such instalment shall, when due, be payable to the Company by the person who is at such time the registered
holder of the shares.
11. Shares may be registered in the names of joint holders not exceeding three in number.
12. Joint holders of a share shall be jointly and severally liable for the payment of all instalments and calls due in respect
of such share. On the death of one or more joint holders of shares the survivor or survivors of them shall alone be
recognized by the Company as the registered holder or holders of the shares.
13. Save as herein otherwise provided, the Company may treat the registered holder of any share as the absolute
owner thereof and accordingly shall not, except as ordered by a court of competent jurisdiction or required by statute,
be bound to recognize any equitable or other claim to or interest in such share on the part of any other person.
Private issuer
14. No security issued by the Company, other than a non-convertible debt security, may be transferred, except
141231
L
U X E M B O U R G
(a) with the consent of the directors of the Company expressed by a resolution of the directors or by a document in
writing signed by a majority of the directors; or
(b) with the consent of the holders of the shares entitled to vote at an ordinary general meeting expressed by a
resolution of the holders of those shares or by a document in writing signed by the holders of the majority of those
shares.
The Company shall not register any other purported transfer of securities. In this Article the term "security" includes
any security within the meaning of such term in the Securities Act (Nova Scotia) or regulations or rules made pursuant
thereto, as the same may be amended from time to time.
Certificates
15. Certificates of title to shares shall comply with the Act and may otherwise be in such form as the directors may
from time to time determine. Unless the directors otherwise determine, every certificate of title to shares shall be signed
manually by at least one of the Chairman, President, Secretary, Treasurer, a vice-president, an assistant secretary, any
other officer of the Company or any director of the Company or by or on behalf of a share registrar transfer agent or
branch transfer agent appointed by the Company or by any other person whom the directors may designate. When
signatures of more than one person appear on a certificate all but one may be printed or otherwise mechanically repro-
duced. All such certificates when signed as provided in this Article shall be valid and binding upon the Company. If a
certificate contains a printed or mechanically reproduced signature of a person, the Company may issue the certificate,
notwithstanding that the person has ceased to be a director or an officer of the Company and the certificate is as valid
as if such person were a director or an officer at the date of its issue,
16. Except as the directors may determine, each shareholder's shares may be evidenced by any number of certificates
so long as the aggregate of the shares stipulated in such certificates equals the aggregate registered in the name of the
shareholder.
17. Where shares are registered in the names of two or more persons, the Company shall not be bound to issue more
than one certificate or set of certificates, and such certificate or set of certificates shall be delivered to the person first
named on the Register.
18. Any certificate that has become worn, damaged or defaced may, upon its surrender to the directors, be cancelled
and replaced by a new certificate. Any certifícate that has become lost or destroyed may be replaced by a new certificate
upon proof of such loss or destruction to the satisfaction of the directors and the furnishing to the Company of such
undertakings of indemnity as the directors deem adequate.
19. The sum of one dollar or such other sum as the directors from time to time determine shall be paid to the Company
for every certificate other than the first certificate issued to any holder in respect of any share or shares.
20. The directors may cause one or more branch Registers of shareholders to be kept in any place or places, whether
inside or outside of Nova Scotia.
Calls
21. The directors may make such calls upon the shareholders in respect of all amounts unpaid on the shares held by
them respectively and not made payable at fixed times by the conditions on which such shares were allotted, and each
shareholder shall pay the amount of every call so made to the person and at the times and places appointed by the
directors. A call may be made payable by instalments.
22. A call shall be deemed to have been made at the time when the resolution of the directors; authorizing such call
was passed.
23. At least 14 days' notice of any call shall be given, and such notice shall specify the time and place at which and the
person to whom such call shall he paid.
24. If the sum payable in respect of any call or instalment is not paid on or before the day appointed for the payment
thereof, the holder for the time being of the share in respect of which the call has been made or the instalment is due
shall pay interest on such call or instalment at the rate of 9% per year or such other rate of interest as the directors may
determine from the day appointed for the payment thereof up to the time of actual payment.
25. At the trial or hearing of any action for the recovery of any amount due for any call, it shall be sufficient to prove
that the name of the shareholder sued is entered on the Register as the holder or one of the holders of the share or
shares in respect of which such debt accrued, mat the resolution making the call is duly recorded in the minute book and
that such notice of such call was duly given to the shareholder sued in pursuance of these Articles. It shall not be necessary
to prove the appointment of the directors who made such call or any other matters whatsoever and the proof of the
matters stipulated shall be conclusive evidence of the debt.
Forfeiture of shares:
26. If any shareholder fails to pay any call or instalment on or before the day appointed for payment, the directors may
at any time thereafter while the call or instalment remains unpaid serve a notice on such shareholder requiring payment
thereof together with any interest that may have accrued and all expenses that may have been incurred by the Company
by reason of such non-payment.
141232
L
U X E M B O U R G
27. The notice shall name a day (not being less than 14 days after the date of the notice) and a place or places on and
at which such call or instalment and such interest and expenses are to be paid. The notice shall also state that, in the
event of non-payment on or before the day and at the place or one of the places so named, the shares in respect of which
the call was made or instalment is payable will be liable to be forfeited.
28. If the requirements of any such notice are not complied with, any shares in respect of which such notice has been
given may at any time thereafter, before payment of all calls or instalments, interest and expenses due in respect thereof,
be forfeited by a resolution of the directors to that effect. Such forfeiture shall include all dividends declared in respect
of the forfeited shares and not actually paid before the forfeiture.
29. When any share has been so forfeited, notice of the resolution shall be given to the shareholder in whose name
it stood immediately prior to the forfeiture and an entry of the forfeiture shall be made in the Register.
30. Any share so forfeited shall be deemed the property of the Company and the directors may sell, re-allot or
otherwise dispose of it in such manner as they think fit.
31. The directors may at any time before any share so forfeited has been sold, re-allotted or otherwise disposed of,
annul the forfeiture thereof upon such conditions as they think fit.
32. Any shareholder whose shares have been forfeited shall nevertheless be liable to pay and shall forthwith pay to
the Company all calls, instalments, interest and expenses owing upon or in respect of such shares at the time of the
forfeiture together with interest thereon at the rate of 9% per year or such other rate of interest as the directors may
determine from the time of forfeiture until payment. The directors may enforce such payment if they think fit, but are
under no obligation to do so.
33. A certificate signed by the Secretary stating that a share has been duly forfeited on a specified date in pursuance
of these Articles and the time when it was forfeited shall be conclusive evidence of the facts therein stated as against any
person who would have been entitled to the share but for such forfeiture.
Lien on shares
34. The Company shall have a first and paramount lien upon all shares (other than fully paid-up shares) registered in
the name of a shareholder (whether solely or jointly with others) and upon the proceeds from the sale thereof for debts,
liabilities and other engagements of the shareholder, solely or jointly with any other person, to or with the Company,
whether or not the period for the payment, fulfilment or discharge thereof has actually arrived, and such lien shall extend
to all dividends declared in respect of such shares. Unless otherwise agreed, the registration of a transfer of shares shall
operate as a waiver of any lien of the Company on such shares.
35. For the purpose of enforcing such lien the directors may sell the shares subject to it in such manner as they think
fit, but no sale shall be made until the period for the payment, fulfilment or discharge of such debts, liabilities or other
engagements has arrived, and until notice in writing of the intention to sell has been given to such shareholder or the
shareholder's executors or administrators and default has been made by them in such payment, fulfilment or discharge
for seven days after such notice.
36. The net proceeds of any such sale after the payment of all costs shall be applied in or towards the satisfaction of
such debts, liabilities or engagements and the residue, if any, paid to such shareholder.
Validity of sales
37. Upon any sale after forfeiture or to enforce a lien in purported exercise of the powers given by these Articles the
directors may cause the purchaser's name to be entered in the Register in respect of the shares sold, and the purchaser
shall not be bound to see to the regularity of the proceedings or to the application of the purchase money, and after the
purchaser's name has been entered in the Register in respect of such shares the validity of the sale shall not be impeached
by any person and the remedy of any person aggrieved by the sale shall be in damages only and against the Company
exclusively.
Transfer of shares
38. The instrument of transfer of any share in the Company shall be signed by the transferor. The transferor shall be
deemed to remain the holder of such share until the name of the transferee is entered in the Register in respect thereof
and shall be entitled to receive any dividend declared thereon before the registration of the transfer.
39. The instrument of transfer of any share shall be in writing in the following form or to the following effect:
For value received, ... hereby sell, assign, and transfer unto ..., ... shares in the capital of the Company represented by
the within certificate, and do hereby irrevocably constitute and appoint ... attorney to transfer such shares on the books
of the Company with full power of substitution in the premises.
Dated the ... day of. ..., ...
Witness:
40. The directors may, without assigning any reason therefor, decline to register any transfer of shares
(1) not fully paid-up or upon which the Company has a lien, or
(2) the transfer of which is restricted by any agreement to which the Company is a party.
141233
L
U X E M B O U R G
41. Every instrument of transfer shall be left for registration at the Office of the Company, or at any office of its transfer
agent where a Register is maintained, together with the certificate of the shares to be transferred and such other evidence
as the Company may require to prove title to or the right to transfer the shares.
42. The directors may require that a fee determined by them be paid before or after registration of any transfer.
43. Every instrument of transfer shall, after its registration, remain in the custody of the Company. Any instrument of
transfer that the directors decline to register shall, except in case of fraud, be returned to the person who deposited it.
Transmission of shares
44. The executors or administrators of a deceased shareholder (not being one of several joint holders) shall be the
only persons recognized by the Company as having any title to the shares registered in the name of such shareholder.
When a share is registered in the names of two or more joint holders, the survivor or survivors or the executors or
administrators of the deceased shareholder, shall be the only persons recognized by the Company as having any title to,
or interest in, such share.
45. Notwithstanding anything in these Articles, if the Company has only one shareholder (not being one of several
joint holders) and that shareholder dies, the executors or administrators of the deceased shareholder shall be entitled
to register themselves in the Register as the holders of the shares registered in the name of the deceased shareholder
whereupon they shall have all the rights given by these Articles and by law to shareholders.
46. Any person entitled to shares upon the death or bankruptcy of any shareholder or in any way other than by
allotment or transfer, upon producing such evidence of entitlement as the directors require, may be registered as a
shareholder in respect of such shares, or may, without being registered, transfer such shares subject to the provisions of
these Articles respecting the transfer of shares. The directors shall have the same right to refuse registration as if the
transferee were named in an ordinary transfer presented for registration.
Surrender of shares
47. The directors may accept the surrender of any share by way of compromise of any question as to the holder being
properly registered in respect thereof. Any share so surrendered may be disposed of in the same manner as a forfeited
share.
Increase and reduction of capital
48. Subject to the Act, the shareholders may by special resolution amend these Articles to increase or alter the share
capital of the Company as they think expedient. Without prejudice to any special rights previously conferred on the
holders of existing shares, any share may be issued with such preferred, deferred or other special rights, or with such
restrictions, whether in regard to dividends, voting, return of share capital or otherwise, as the shareholders may from
time to time determine by special resolution. Except as otherwise provided by the conditions of issue, or by these Articles,
any capital raised by the creation of new shares shall be considered part of the original capital and shall be subject to the
provisions herein contained with reference to payment of calls and instalments, transfer and transmission, forfeiture, lien
and otherwise.
49. The Company may, by special resolution where required, reduce its share capital in any way and with and subject
to any incident authorized and consent required by law. Subject to the Act and any provisions attached to such shares,
the Company may redeem, purchase or acquire any of its shares and the directors may determine the manner and the
terms for redeeming, purchasing or acquiring such shares and may provide a sinking fund on such terms as they think fit
for the redemption, purchase or acquisition of shares of any class or series.
Meetings and voting by class or series
50. Where the holders of shares of a class or series have, under the Act, the terms or conditions attaching to such
shares or otherwise, the right to vote separately as a class in respect of any matter then, except as provided in the Act,
these Articles or such terms or conditions, all the provisions in these Articles concerning general meetings (including,
without limitation, provisions respecting notice, quorum and procedure) shall, mutatis mutandis, apply to every meeting
of holders of such class or series of shares convened for the purpose of such vote.
51. Unless the rights, privileges, terms or conditions attached to a class or series of shares provide otherwise, such
class or series of shares shall not have the right to vote separately as a class or series upon an amendment to the
Memorandum or Articles to:
(1) increase or decrease any maximum number of authorized shares of such class or series, or increase any maximum
number of authorized shares of a class or series having rights or privileges equal or superior to the shares of such class
or series;
(2) effect an exchange, reclassification or cancellation of all or part of the shares of such class or series; or
(3) create a new class or series of shares equal or superior to the shares of such class or series.
Borrowing powers
52. The directors on behalf of the Company may:
141234
L
U X E M B O U R G
(1) raise or borrow money for the purposes of the Company or any of them;
(2) secure, subject to the sanction of a special resolution where required by the Act, the repayment of funds so raised
or borrowed in such manner and upon such terms and conditions in all respects as they think fit, and in particular by the
execution and -delivery of mortgages of the Company's real or personal property, or by the issue of-bonds, debentures
or other securities of the Company secured by mortgage or other charge upon all or any part of the property of the
Company, both present and future including its uncalled capital for the time being;
(3) sign or endorse bills, notes, acceptances, cheques, contracts, and other evidence of or securities for funds borrowed
or to be borrowed for the purposes aforesaid;
(4) pledge debentures as security for loans;
(5) guarantee obligations of any person.
53. Bonds, debentures and other securities may be made assignable, free from any equities between the Company and
the person to whom such securities were issued.
54. Any bonds, debentures and other securities may be issued at a discount, premium or otherwise and with special
privileges as to redemption, surrender, drawings, allotment of shares, attending and voting at general meetings of the
Company, appointment of directors and other matters.
General meetings
55. Ordinary general meetings of the Company shall be held at least once in every calendar year at such time and place
as may be determined by the directors and not later than 15 months after the preceding ordinary general meeting. All
other meetings of the Company shall be called special general meetings. Ordinary or special general meetings may be
held either within or without the Province of Nova Scotia.
56. The President, a vice-president or the directors may at any time convene a special general meeting, and the
directors, upon the requisition of shareholders in accordance with the Act shall forthwith proceed to convene such
meeting or meetings to be held at such time and place or times and places as the directors determine.
57. The requisition shall state the objects of the meeting requested, be signed by the requisitionists and deposited at
the Office of the Company. It may consist of several documents in like form each signed by one or more of the requisi-
tionists.
58. At least seven clear days' notice, or such longer period of notice as may be required by the Act, of every general
meeting, specifying the place, day and hour of the meeting and, when special business is to be considered, the general
nature of such business, shall be given to the shareholders entitled to be present at such meeting by notice given as
permitted by these Articles, With the consent in writing of all the shareholders entitled to vote at such meeting, a meeting
may be convened by a shorter notice and in any manner they think fit, or notice of the time, place and purpose of the
meeting may be waived by all of the shareholders.
59. When it is proposed to pass a special resolution, the two meetings may be convened by the -same notice, and it
shall be no objection to such notice that it only convenes the second meeting contingently upon the resolution being
passed by the requisite majority at the first meeting.
60. The accidental omission to give notice to a shareholder, or non-receipt of notice by a shareholder, shall not
invalidate any resolution passed at any general meeting.
Record dates
61. (1) The directors may fix in advance a date as the record date for the determination of shareholders
(a) entitled to receive payment of a dividend or entitled to receive any distribution;
(b) entitled to receive notice of a meeting; or
(c) for any other purpose.
(2) If no record date is fixed, the record date for the determination of shareholders
(a) entitled to receive notice of a meeting shall be the day immediately preceding the day on which the notice is given,
or, if no notice is given, the day on which the meeting is held; and
(b) for any other purpose shall be the day on which the directors pass the resolution relating to the particular purpose.
Proceedings at general meetings
62. The business of an ordinary general meeting shall be to receive and consider the financial statements of the Company
and the report of the directors and the report, if any, of the auditors, to elect directors in the place of those retiring and
to transact any other business which under these Articles, ought to be transacted at an ordinary general meeting.
63. No business shall be transacted at any general meeting unless the requisite quorum is present at the commencement
of the business. A corporate shareholder of the Company that has a duly authorized agent or representative present at
any such meeting shall for the purpose of this Article be deemed to be personally present at such meeting,
64. One person, being a shareholder, proxyholder or representative of a corporate shareholder, present and entitled
to vote shall constitute a quorum for a general meeting, and may hold a meeting.
141235
L
U X E M B O U R G
65. The Chairman shall be entitled to take the chair at every general meeting or, if there be no Chairman, or if the
Chairman is not present within fifteen 15 minutes after the time appointed -for holding the meeting, the President or,failing
the President, a vice-president shall be entitled to take the chair. If the Chairman, the President or a vice-president is not
present within 15 minutes after the time appointed for holding the meeting or if all such persons present decline to take
the chair, the shareholders present entitled to vote at the meeting shall choose another director as chairman and if no
director is present or if all the directors present decline to take the chair, then such shareholders shall choose one of
their number to be chairman.
66. If within half an hour from the time appointed for a general meeting a quorum is not present, the meeting, if it was
convened pursuant to a requisition of shareholders, shall be dissolved; if it was convened in any other way, it shall stand
adjourned to the same day, in the next week, at the same time and place. If at the adjourned meeting a quorum is not
present within half an hour from the time appointed for the meeting, the shareholders present shall be a quorum and
may hold the meeting.
67. Subject to the Act, at any general meeting a resolution put to the meeting shall be decided by a show of hands
unless, either before or on the declaration of the result of the show of hands, a poll is demanded by the chairman, a
shareholder or a proxyholder; and unless a poll is so demanded, a declaration by the chairman that the resolution has
been carried, carried by a particular majority, lost or not carried by a particular majority and an entry to that effect in
the Company's book of proceedings shall be conclusive evidence of the fact without proof of the number or proportion
of the votes recorded in favour or against such resolution.
68. When a poll is demanded, it shall be taken in such manner and at such time and place as the chairman directs, and
either at once or after an interval or adjournment or otherwise. The result of the poll shall be the resolution of the
meeting at which the poll was demanded. The demand of a poll may be withdrawn. When any dispute occurs over the
admission or rejection of a vote, it shall be resolved by the chairman and such determination made in good faith shall be
final and conclusive.
69. The chairman shall not have a casting vote in addition to any vote or votes that the chairman has as a shareholder.
70. The chairman of a general meeting may with the consent of the meeting adjourn the meeting from time to time
and from place to place, but no business shall be transacted at any adjourned meeting other than the business left unfinished
at the meeting that was adjourned.
71. Any poll demanded on the election of a chairman or on a question of adjournment shall he taken forthwith without
adjournment.
72. The demand of a poll shall not prevent the continuance of a meeting for the transaction of any business other than
the question on which a poll has been demanded.
Votes of shareholders
73. Subject to the Act and to any provisions attached to any class or series of shares concerning or -restricting voting
rights:
(1) on a show of hands every shareholder entitled to vote present in person, every duly authorized representative of
a corporate shareholder, and, if not prevented from voting by the Act, every proxyholder, shall have one vote; and
(2) on a poll every shareholder present in person, every duly authorized representative of a corporate shareholder,
and every proxyholder, shall have one vote for every share held;
whether or not such representative or proxyholder is a shareholder.
74. Any person entitled to transfer shares upon the death or bankruptcy of any shareholder or in any way other than
by allotment or transfer may vote at any general meeting in respect thereof in the same manner as if such person were
the registered holder of such shares so long as the directors are satisfied at least 48 hours before the time of holding the
meeting of such person's right to transfer such shares.
75. Where there are joint registered holders of any share, any of such holders may vote such share at any meeting,
either personally or by proxy, as if solely entitled to it If more than one joint holder is present at any meeting, personally
or by proxy, the one whose name stands first on the Register in respect of such share shall alone be entitled to vote it.
Several executors or administrators of a deceased shareholder in whose name any share stands shall for the purpose of
this Article be deemed joint holders thereof
76. Votes may be cast either personally or by proxy or, in the case of a corporate shareholder by a representative
duly authorized under the Act.
77. A proxy shall be in writing and executed in the manner provided in the Act. A proxy or other authority of a
corporate shareholder does not require its seal.
78. A shareholder of unsound mind in respect of whom an order has been made by any court of competent jurisdiction
may vote by guardian or other person in the nature of a guardian appointed by that court, and. any such guardian or other
person may vote by proxy.
79. A proxy and the power of attorney or other authority, if any, under which it is signed or a notarially certified copy
of that power or authority shall be deposited at the Office of the Company or at such other place as the directors may
direct. The directors may, by resolution, fix a time not exceeding 48 hours excluding Saturdays and holidays preceding
141236
L
U X E M B O U R G
any meeting or adjourned meeting before which time proxies to be used at that meeting must be deposited with the
Company at its Office or with an agent of the Company. Notice of the requirement for depositing proxies shall be given
in the notice calling the meeting. The chairman of the meeting shall determine all questions as to validity of proxies and
other instruments of authority.
80. A vote given in accordance with the terms of a proxy shall be valid notwithstanding the previous death of the
principal, the revocation of the proxy, or the transfer of the share in respect of which the vote is given, provided no
intimation in writing of the death, revocation or transfer is received at the Office of the Company before the meeting or
by the chairman of the meeting before the vote is given.
81. Every form of proxy shall comply with the Act and its regulations and subject thereto may be in the following form:
I, ... of ... being a shareholder of hereby appoint ... of (or failing him/her ... of ...) as my proxyholder to attend and to
vote for me and on my behalf at the ordinary/special general meeting of the Company, to be held on the day of and at
any adjournment thereof, or at any meeting of the Company which may be held prior to [insert specified date or event].
[If the proxy is solicited by or behalf of the management of the Company, insert a statement to mat effect.]
Dated mis ... day of ....
Shareholder
82. Subject to the Act, no shareholder shall be entitled to be present or to vote on any question, either personally or
by proxy, at any general meeting or be reckoned in a quorum while any call is due and payable to the Company in respect
of any of the shares of such shareholder.
83. Any resolution passed by the directors, notice of which has been given to the shareholders in the manner in which
notices are hereinafter directed to be given and which is, within one month after it has been passed, ratified and confirmed
in writing by shareholders entitled on a poll to three-fifths of the votes, shall be as valid and effectual as a resolution of a
general meeting. This Article shall not apply to a resolution for winding up the Company or to a resolution dealing with
any matter that by statute or these Articles ought to be dealt with by a special resolution or other method prescribed
by statute.
84. A resolution, including a special resolution, in writing and signed by every shareholder who would be entitled to
vote on the resolution at a meeting is as valid as if it were passed by such shareholders at a meeting and satisfies all of
the requirements of the Act respecting meetings of shareholders.
Directors
85. Unless otherwise determined by resolution of shareholders, the number of directors shall not be less than one or
more than ten.
86. Notwithstanding anything herein contained the subscribers to the Memorandum shall be the first directors of the
Company.
87. The directors may be paid out of the funds of the Company as remuneration for their service -such sums, if any,as
the Company may by resolution of its shareholders determine, and such remuneration shall be divided among them in
such proportions and manner as the directors determine. The directors may also be paid their reasonable travelling, hotel
and other expenses incurred in attending meetings of directors and otherwise in the execution of their duties as directors.
88. The continuing directors may act notwithstanding any vacancy in their body, but if their number falls below the
minimum permitted, the directors shall not, except in emergencies or for the purpose of filling vacancies, act so long as
their number is below the minimum.
89. A director may, in conjunction with the office of director, and on such terms as to remuneration and otherwise
as the directors arrange or determine, hold any other office or place of profit under the Company or under any company
in which the Company is a shareholder or is otherwise interested.
90. The office of a director shall ipso facto be vacated, if the director:
(1) becomes bankrupt or makes an assignment for the benefit of creditors;
(2) is, or is found by a court of competent jurisdiction to be, of unsound mind;
(3) by notice in writing to the Company, resigns the office of director; or
(4) is removed in the manner provided by these Articles.
91. No director shall be disqualified by holding the office of director from contracting with the Company, either as
vendor, purchaser, or otherwise, nor shall any such contract, or any contract or arrangement entered into or proposed
to be entered into by or on behalf of the Company in which any director is in any way interested, either directly or
indirectly, be avoided, nor shall any director so contracting or being so interested be liable to account to the Company
for any profit realized by any such contract or arrangement by reason only of such director holding that office or of the
fiduciary relations thereby established, provided the director makes a declaration or gives a general notice in accordance
with the Act. No director shall, as a director, vote in respect of any contract or arrangement in which the director is so
interested, and if the director does so vote, such vote shall not be counted. This prohibition may at any time or times be
suspended or relaxed to any extent by a resolution of the shareholders and shall not apply to any contract by or on behalf
of the Company to give to the directors or any of them any security for advances or by way of indemnity.
141237
L
U X E M B O U R G
Election of directors
92. At the dissolution of every ordinary general meeting at which their successors are elected, all the directors shall
retire from office and be succeeded by the directors elected at such meeting. Retiring directors shall be eligible for re-
election.
93. If at any ordinary general meeting at which an election takes place, or if no ordinary general meeting is held in any
year or period of years, the retiring directors shall continue in office until their successors are elected.
94. The Company may by resolution of its shareholders elect any number of directors permitted by these Articles and
may determine or alter their qualification,
95. The Company may, by special resolution or in any other manner permitted by statute, remove any director before
the expiration of such director's period of office and may, if desired, appoint a replacement to hold office during such
time only as the director so removed would have held office.
96. The directors may appoint any other person as a director so long as the total number of directors does not at any
time exceed the maximum number permitted. No such appointment, except to fill a casual vacancy, shall be effective
unless two-thirds of the directors concur in it. Any casual vacancy occurring among the directors may be filled by the
directors, but any person so chosen shall retain office only so long as the vacating director would have retained it if the
vacating director had continued as director.
Managing director
97. The directors may appoint one or more of their body to be managing directors of the Company, either for a fixed
term or otherwise, and may remove or dismiss them from office and appoint replacements.
98. Subject to the provisions of any contract between a managing director and the Company, a managing director shall
be subject to the same provisions as to resignation and removal as the other directors of the Company. A managing
director who for any reason ceases to hold the office of director shall ipso facto immediately cease to be a managing
director.
99. The remuneration of a managing director shall from time to time be fixed by the directors and may be by way of
any or all of salary, commission and participation in profits.
100. The directors may from time to time entrust to and confer upon a managing director such of the powers exer-
cisable under these Articles by the directors as they think fit, and may confer such powers for such time, and to be
exercised for such objects and purposes and upon such terms and conditions, and with such restrictions as they think
expedient; and they may confer such powers either collaterally with, or to the exclusion of, and in substitution for, all or
any of the powers of the directors in that behalf; and may from time to time revoke, withdraw, alter or vary all or any
of such powers.
Chairman of the board
101. The directors may elect one of their number to be Chairman and may determine the period during which the
Chairman is to hold office. The Chairman shall perform such duties and receive such special remuneration as the directors
may provide.
President and vice-presidents
102. The directors shall elect the President of the Company, who need not be a director, and may determine the
period for which the President is to hold office. The President shall have general supervision of the business of the
Company and shall perform such duties as may be assigned from time to time by the directors.
103. The directors may also elect vice-presidents, who need not be directors, and may determine the periods for
which they are to hold office. A vice-president shall, at the request of the President or the directors and subject to the
directions of the directors, perform the duties of the President during the absence, illness or incapacity of the President,
and shall also perform such duties as may be assigned by the President or the directors.
Secretary and treasurer
104. The directors shall appoint a Secretary of the Company to keep minutes of shareholders' and directors' meetings
and perform such other duties as may be assigned by the directors. The directors may also appoint a temporary substitute
for the Secretary who shall, for the purposes of these Articles, be deemed to be the Secretary.
105. The directors may appoint a treasurer of the Company to carry out such duties as the directors may assign.
Officers
106. The directors may elect or appoint such other officers of the Company, having such powers and duties, as they
think fit.
107. If the directors so decide the same person may hold more than one of the orifices provided for in these Articles.
141238
L
U X E M B O U R G
Proceedings of directors
108. The directors may meet together for the dispatch of business, adjourn and otherwise regulate their meetings and
proceedings, as they think fit, and may determine the quorum necessary for the transaction of business. Until otherwise
determined, one director shall constitute a quorum and may hold a meeting.
109. If all directors of the Company entitled to attend a meeting either generally or specifically consent, a director
may participate in a meeting of directors or of a committee of directors by means of such telephone or other commu-
nications facilities as permit all persons participating in the meeting to hear each other, and a director participating in such
a meeting by such means is deemed to he present at that meeting for purposes of these Articles.
110. Meetings of directors may be held either within or without the Province of Nova Scotia and the directors may
from time to time make arrangements relating to the time and place of holding directors' meetings, the notices to be
given for such meetings and what meetings may be held without notice. Unless otherwise provided by such arrangements:
(1) A meeting of directors may be held at the close of every ordinary general meeting of the Company without notice.
(2) Notice of every other directors' meeting may be given as permitted by these Articles to each director at least 48
hours before the time fixed for the meeting.
(3) A meeting of directors may be held without formal notice if all the directors are present or if those absent have
signified their assent to such meeting or their consent to the business transacted at such meeting.
111. The President or any director may at any time, and the Secretary, upon the request of the President or any
director, shall summon a meeting of the directors to be held at the Office of the Company. The President, the Chairman
or a majority of the directors may at any time, and the Secretary, upon the request of the President, the Chairman or a
majority of the directors shall, summon a meeting to be held elsewhere.
112. (1) Questions arising at any meeting of directors shall be decided by a majority of votes. The chairman of the
meeting may vote as a director but shall not have a second or casting vote.
(2) At any meeting of directors the chairman shall receive and count the vote of any director not present in person
at such meeting on any question or matter arising at such meeting whenever such absent director has indicated by
telegram, letter or other writing lodged with the chairman Of such meeting the manner in which the absent director
desires to vote on such question or matter and such question or matter has been specifically mentioned in the notice
calling the meeting as a question or matter to be discussed or decided thereat. In respect of any such question or matter
so mentioned in such notice any director may give to any other director a proxy authorizing such other director to vote
for such first named director at such meeting, and the chairman of such meeting, after such proxy has been so lodged,
shall receive and count any vote given in pursuance thereof notwithstanding the absence of the director giving such proxy.
113. If no Chairman is elected, or if at any meeting of directors the Chairman is not present within five minutes after
the time appointed for holding the meeting, or declines to take the chair, the President, if a director, shall preside. If the
President is not a director, is not present at such time or declines to take the chair, a vice-president who is also a director
shall preside. If no person described above is present at such time and willing to take the chair, the directors present shall
choose some one of their number to be chairman of the meeting.
114. A meeting of the directors at which a quorum is present shall be competent to exercise all or any of the authorities,
powers and discretions for the time being vested in or exercisable by the directors generally.
115. The directors may delegate any of their powers to committees consisting of such number of directors as they
think fit. Any committee so formed shall in the exercise of the powers so delegated conform to any regulations that may
be imposed on them by the directors.
116. The meetings and proceedings of any committee of directors shall be governed by the provisions contained in
these Articles for regulating the meetings and proceedings of the directors insofar as they are applicable and are not
superseded by any regulations made by the directors.
117. All acts done at any meeting of the directors or of a committee of directors or by any person acting as a director
shall, notwithstanding that it is afterwards discovered that there was some defect in the appointment of the director or
person so acting, or that they or any of them were disqualified, be as valid as if every such person had been duly appointed
and was qualified to be a director.
118. A resolution in writing and signed by every director who would be entitled to vote on the resolution at a meeting
is as valid as if it were passed by such directors at a meeting.
119. If any one or more of the directors is called upon to perform extra services or to make any special exertions in
going or residing abroad or otherwise for any of the purposes of the Company or the business thereof, the Company
may remunerate the director or directors so doing, either by a fixed sum or by a percentage of profits or otherwise.
Such remuneration shall be determined by the directors and may be either in addition to or in substitution for remune-
ration otherwise authorized by these Articles.
Registers
120. The directors shall cause to be kept at the Company's Office in accordance with the provisions of the Act a
Register of the shareholders of the Company, a register of the holders of bonds, debentures and other securities of the
Company and a register of its directors. Branch registers of the shareholders and of the holders of bonds, debentures
141239
L
U X E M B O U R G
and other securities may be kept elsewhere, either within or without the Province of Nova Scotia, in accordance with
the Act.
Minutes
121. The directors shall cause minutes to be entered in books designated for the purpose:
(1) of all appointments of officers;
(2) of the names of directors present at each meeting of directors and of any committees of directors;
3) of all orders made by the directors and committees of directors; and
(4) of all resolutions and proceedings of meetings of shareholders and of directors.
Any such minutes of any meeting of directors or of any committee of directors or of shareholders, if purporting to
be signed by the chairman of such meeting or by the chairman of the next succeeding meeting, shall be receivable as prima
facie evidence of the matters stated in such minutes.
Powers of directors
122. The management of the business of the Company is vested in the directors who, in addition to the powers and
authorities by these Articles or otherwise expressly conferred upon them, may exercise all such powers and do all such
acts and things as may be exercised or done by the Company and are not hereby or by statute expressly directed or
required to be exercised or done by the shareholders, but subject nevertheless to the provisions of any statute, the
Memorandum or these Articles. No modification of the Memorandum or these Articles shall invalidate any prior act of
the directors that would have been valid if such modification had not been made.
123. Without restricting the generality of the terms of any of these Articles and without prejudice to the powers
conferred thereby, the directors may:
(1) take such steps as they think fit to carry out any agreement or contract made by or on behalf of the Company;
(2) pay costs, charges and expenses preliminary and incidental to the promotion, formation, establishment, and regis-
tration of the Company;
(3) purchase or otherwise acquire for the Company any property, rights or privileges that the Company is authorized
to acquire, at such price and generally on such terms and conditions as they think fit;
(4) pay for any property, rights or privileges acquired by, or services rendered to the Company either wholly or partially
in cash or in shares (fully paid-up or otherwise), bonds, debentures or other securities of the Company;
(5) subject to the Act, secure the fulfilment of any contracts or engagements entered into by the Company by mort-
gaging or charging all or any of the property of the Company and its unpaid capital for the time being, or in such other
manner as they think fit;
(6) appoint, remove or suspend at their discretion such experts, managers, secretaries, treasurers, officers, clerks,
agents and servants for permanent, temporary or special services, as they from time to time think fit, and determine their
powers and duties and fix their salaries or emoluments and require security in such instances and to such amounts as
they think fit;
(7) accept a surrender of shares from any shareholder insofar as the law permits and on such terms and conditions as
may be agreed;
(8) appoint any person or persons to accept and hold in trust for the Company any property belonging to the Company,
or in which it is interested, execute and do all such deeds and things as may be required in relation to such trust, and
provide for the remuneration of such trustee or trustees;
(9) institute, conduct, defend, compound or abandon any legal proceedings by and against the Company, its directors
or its officers or otherwise concerning the affairs of the Company, and also compound and allow time for payment or
satisfaction of any debts due and of any claims or demands by or against the Company;
(10) refer any claims or demands by or against the Company to arbitration and observe and perform the awards;
(11) make and give receipts, releases and other discharges for amounts payable to the Company and for claims and
demands of the Company;
(12) determine who may exercise the borrowing powers of the Company and sign on the Company's behalf bonds,
debentures or other securities, bills, notes, receipts, acceptances, assignments, transfers, hypothecations, pledges, en-
dorsements, cheques, drafts, releases, contracts, agreements and all other instruments and documents;
(13) provide for the management of the affairs of the Company abroad in such manner as they think fit, and in particular
appoint any person to be the attorney or agent of the Company with such powers (including power to sub-delegate) and
upon such terms as maybe thought fit;
(14) invest and deal with any funds of the Company in such securities and in such manner as they think fit; and vary
or realize such investments;
(15) subject to the Act, execute in the name and on behalf of the Company in favour of any director or other person
who may incur or be about to incur any personal liability for the benefit of the Company such mortgages of the Company's
property, present and future, as they think fit;
141240
L
U X E M B O U R G
(16) give any officer or employee of the Company a commission on the profits of any particular business or transaction
or a share in the general profits of the Company;
(17) set aside out of the profits of the Company before declaring any dividend such amounts as they think proper as
a reserve fund to meet contingencies or provide for dividends, depreciation, repairing, improving and maintaining any of
the property of the Company and such other purposes as the directors may in their absolute discretion think in the
interests of the Company; and invest such amounts in such investments as they think fit, and deal with and vary such
investments, and dispose of all or any part of them for the benefit of the Company, and divide the reserve fund into such
special funds as they think fit, with full power to employ the assets constituting the reserve fond in the business of the
Company without being bound to keep them separate from the other assets;
(18) make, vary and repeal rules respecting the business of the Company, its officers and employees, the shareholders
of the Company or any section or class of them;
(19) enter into all such negotiations and contracts, rescind and vary all such contracts, and execute and do all such
acts, deeds and things in the name and on behalf of the Company as they consider expedient for or in relation to any of
the matters aforesaid or otherwise for the purposes of the Company;
(20) provide for the management of the affairs of the Company in such manner as they think fit.
Solicitors
124. The Company may employ or retain solicitors any of whom may, at the request or on the instruction of the
directors, the Chairman, the President or a managing director, attend meetings of the directors or shareholders, whether
or not the solicitor is a shareholder or a director of the Company. A solicitor who is also a director may nevertheless
charge for services rendered to the Company as a solicitor.
The seal
125. The directors shall arrange for the safe custody of the common seal of the Company (the "Seal"). The Seal may
he affixed to any instrument in the presence of and contemporaneously with the attesting signature of (i) any director or
officer acting within such person's authority or (ii) any person under the authority of a resolution of the directors or a
committee thereof. For the purpose of certifying documents or proceedings the Seal may be affixed by any director or
the President, a vice-president, the Secretary, an assistant secretary or any other officer of the Company without the
authorization of a resolution of the directors.
126. The Company may have facsimiles of the Seal which may be used interchangeably with the Seal.
127. The Company may have for use at any place outside the Province of Nova Scotia, as to all matters to which the
corporate existence and capacity of the Company extends, an official seal that is a facsimile of the Seal of the Company
with the addition on its face of the name of the place where it is to he used; and the Company may by writing under its
Seal authorize any person to affix such official seal at such place to any document to which the Company is a party.
Dividends
128. The directors may from time to time declare such dividend as they deem proper upon shares of the Company
according to the rights and restrictions attached to any class or series of shares, and may determine the date upon which
such dividend will be payable and that it will be payable to the persons registered as the holders of the shares on which
it is declared at the close of business upon a record date. No transfer of such shares registered after the record date
shall pass any right to the dividend so declared.
129. Dividends may be paid as permitted by law and, without limitation, may be paid out of the profits, retained earnings
or contributed surplus of the Company. No interest shall be payable on any dividend except insofar as the rights attached
to any class or series of shares provide otherwise.
130. The declaration of the directors as to the amount of the profits, retained earnings or contributed surplus of the
Company shall be conclusive.
131. The directors may from time to time pay to the shareholders such interim dividends as in their judgment the
position of the Company justifies.
132. Subject to these Articles and the rights and restrictions attached to any class or series of shares, dividends may
be declared and paid to the shareholders in proportion to the amount of capital paid-up on the shares (not including any
capital paid-up bearing interest) held by them respectively.
133. The directors may deduct from the dividends payable to any shareholder amounts due and payable by the sha-
reholder to the Company on account of calls, instalments or otherwise, and may apply the same in or towards satisfaction
of such amounts so due and payable.
134. The directors may retain any dividends on which the Company has a lien, and may apply the same in or towards
satisfaction of the debts, liabilities or engagements in respect of which the lien exists.
135. The directors may retain the dividends payable upon shares to which a person is entitled or entitled to transfer
upon the death or bankruptcy of a shareholder or in any way other than by allotment or transfer, until such person has
become registered as the holder of such shares or has duly transferred such shares.
141241
L
U X E M B O U R G
136. When the directors declare a dividend on a class or series of shares and also make a call on such shares payable
on or before the date on which the dividend is payable, the directors may retain all or part of the dividend and set off
the amount retained against the call.
137. The directors may declare that a dividend be paid by the distribution of cash, paid-up shares (at par or at a
premium), debentures, bonds or other securities of the Company or of any other company or any other specific assets
held or to be acquired by the Company or in any one or more of such ways.
138. The directors may settle any difficulty that may arise in regard to the distribution of a dividend as they think
expedient, and in particular without restricting the generality of the foregoing may issue fractional certificates, may fix
the value for distribution of any specific assets, may determine that cash payments will be made to any shareholders upon
the footing of the value so fixed or mat fractions may be disregarded in order to adjust the rights of all parties, and may
vest cash or specific assets in trustees upon such trusts for the persons entitled to the dividend as may seem expedient
to the directors.
139. Any person registered as a joint holder of any share may give effectual receipts for all dividends and payments on
account of dividends in respect of such share.
140. Unless otherwise determined by the directors, any dividend may be paid by a cheque or warrant delivered to or
sent through the post to the registered address of the shareholder entitled, or, when there are joint holders, to the
registered address of that one whose name stands first on the register for the shares jointly held. Every cheque or warrant
so delivered or sent shall be made payable to the order of the person to whom it is delivered or sent The mailing or
other transmission to a shareholder at the shareholder's registered address (or, in the case of joint shareholders at the
address of the holder whose name stands first on the register) of a cheque payable to the order of the person to whom
it is addressed for the amount of any dividend payable in cash after the deduction of any tax which the Company has
properly withheld, shall discharge the Company's liability for the dividend unless the cheque is not paid on due presen-
tation. If any cheque for a dividend payable in cash is not received, the Company shall issue to the shareholder a
replacement cheque for the same amount on such terms as to indemnity and evidence of non-receipt as the directors
may impose. No shareholder may recover by action or other legal process against the Company any dividend represented
by a cheque that has not been duly presented to a banker of the Company for payment or that otherwise remains
unclaimed for 6 years from the date on which it was payable.
Accounts
141. The directors shall cause proper books of account to be kept of the amounts received and expended by the
Company, the matters in respect of which such receipts and expenditures take place, all sales and purchases of goods by
the Company, and the assets, credits and liabilities of the Company.
142. The books of account shall be kept at the head office of the Company or at such other place or places as the
directors may direct.
143. The directors shall from time to time determine whether and to what extent and at what times and places and
under what conditions the accounts and books of the Company or any of them shall be open to inspection of the
shareholders, and no shareholder shall have any right to inspect any account or book or document of the Company
except as conferred by statute or authorized by the directors or a resolution of the shareholders.
144. At the ordinary general meeting in every year the directors shall lay before the Company such financial statements
and reports in connection therewith as may be required by the Act or other applicable statute or regulation thereunder
and shall distribute copies thereof at such times and to such persons as may be required by statute or regulation.
Auditors and audit
145. Except in respect of a financial year for which the Company is exempt from audit requirements in the Act, the
Company shall at each ordinary general meeting appoint an auditor or auditors to hold office until the next ordinary
general meeting. If at any general meeting at which the appointment of an auditor or auditors is to take place and no such
appointment takes place, or if no ordinary general meeting is held in any year or period of years, the directors shall appoint
an auditor or auditors to hold office until the next ordinary general meeting.
146. The first auditors of the Company may be appointed by the directors at any time before the first ordinary general
meeting and the auditors so appointed shall hold office until such meeting unless previously removed by a resolution of
the shareholders, in which event the shareholders may appoint auditors.
147. The directors may fill any casual vacancy in the office of the auditor hut while any such vacancy continues the
surviving or continuing auditor or auditors, if any, may act.
148. The Company may appoint as auditor any person, including a shareholder, not disqualified by statute.
149. An auditor may be removed or replaced in the circumstances and in the manner specified in the Act.
150. The remuneration of the auditors shall be fixed by the shareholders, or by the directors pursuant to authorization
given by the shareholders, except that the remuneration of an auditor appointed to fill a casual vacancy may be fixed by
the directors.
151. The auditors shall conduct such audit as may be required by the Act and their report, if any, shall be dealt with
by the Company as required by the Act.
141242
L
U X E M B O U R G
Notices
152. A notice (including any communication or document) shall be sufficiently given, delivered or served by the Com-
pany upon a shareholder, director, officer or auditor by personal delivery at such person's registered address (or, in the
case of a director, officer or auditor, last known address) or by prepaid mail, telegraph, telex, facsimile machine or other
electronic means of communication addressed to such person at such address,
153. Shareholders having no registered address shall not be entitled to receive notice.
154. All notices with respect to registered shares to which persons are jointly entitled may be sufficiently given to all
joint holders thereof by notice given to whichever of such persons is named first in the Register for such shares.
155. Any notice sent by mail shall be deemed to be given, delivered or served on the earlier of actual receipt and the
third business day following that upon which it is mailed, and in proving such service it shall be sufficient to prove that
the notice was properly addressed and mailed with the postage prepaid thereon. Any notice given by electronic means
of communication shall be deemed to be given when entered into the appropriate transmitting device for transmission.
A certificate in writing signed on behalf of the Company mat the notice was so addressed and mailed or transmitted shall
be conclusive evidence thereof.
156. Every person who by operation of law, transfer or other means whatsoever becomes entitled to any share shall
be bound by every notice in respect of such share that prior to such person's name and address being entered on the
Register was duly served in the manner hereinbefore provided upon the person from whom such person derived title to
such share.
157. Any notice delivered, sent or transmitted to the registered address of any shareholder pursuant to these Articles,
shall, notwithstanding that such shareholder is then deceased and that the Company has notice thereof, be deemed to
have been served in respect of any registered shares, whether held by such deceased shareholder solely or jointly with
other persons, until some other person is registered as the holder or joint holder thereof and such service shall for all
purposes of these Articles be deemed a sufficient service of such notice on the heirs, executors or administrators of the
deceased shareholder and all joint holders of such shares.
158. Any notice may bear the name or signature, manual or reproduced, of the person giving the notice written or
printed.
159. When a given number of days' notice or notice extending over any other period is required to be given, the day
of service and the day upon which such notice expires shall not, unless it is otherwise provided, be counted in such
number of days or other period.
Indemnity
160. Every director or officer, former director or officer, or person who acts or acted at the Company's request, as
a director or officer of the Company, a body corporate, partnership or other association of which the Company is or
was a shareholder, partner, member or creditor, and the heirs and legal representatives of such person, in the absence
of any dishonesty on the part of such person, shall be indemnified by the Company against, and it shall be the duty of the
directors out of the funds of the Company to pay, all costs, losses and expenses, including an amount paid to settle an
action or claim or satisfy a judgment, mat such director, officer or person may incur or become liable to pay in respect
of any claim made against such person or civil, criminal or administrative action or proceeding to which such person is
made a party by reason of being or having been a director or officer of the Company or such body corporate, partnership
or other association, whether the Company is a claimant or party to such action of proceeding or otherwise; and the
amount for which such, indemnity is proved shall immediately attach as a lien on the property of the Company and have
priority as against the shareholders over all other claims.
161. No director or officer, former director or officer, or person who acts or acted at the Company's request, as a
director or officer of the Company, a body corporate, partnership or other association of which the Company is or was
a shareholder, partner, member or creditor, in the absence of any dishonesty on such person's part, shall be liable for
the acts, receipts, neglects or defaults of any other director, officer or such person, or for joining in any receipt or other
act for conformity, or for any loss, damage or expense happening to the Company through the insufficiency or deficiency
of title to any property acquired for or on behalf of the Company, or through the insufficiency or deficiency of any security
in or upon which any of the funds of the Company are invested, or for any loss or damage arising from the bankruptcy,
insolvency or tortious acts of any person with whom any funds, securities or effects are deposited, or for any loss
occasioned by error of judgment or oversight on the part of such person, or for any other loss, damage or misfortune
whatsoever which happens in the execution of the duties of such person or in relation thereto.
Execution of documents and instruments
162. Deeds, transfers, assignments, contracts, obligations, certificates and other instruments and documents of any
description whatsoever shall be effectively authorized by and signed on behalf of the Company if signed by any director
or officer acting within such person's authority, whether under seal or otherwise as such signatories may see fit. In addition,
the board of directors or the shareholders may from time to time by resolution direct the manner in which and the
person or persons by whom any particular document or instrument or class of documents or instruments may or shall
be signed. Any articles, notice, resolution, requisition, statement or other document or instrument required or permitted
141243
L
U X E M B O U R G
to be executed by more than one person may be executed in several documents or instruments of like form each of
which is executed by one or more of such persons, and such documents or instruments, when duly executed by all
persons required or permitted, as the case may be, to do so, shall be deemed to constitute one document for all relevant
purposes. The secretary or any other officer or any director may sign certificates and similar instruments on the Com-
pany's behalf with respect to any factual matters relating to the Company's business and affairs, including certificates
verifying copies of the constating documents, resolutions and minutes of meetings of the Company.
Reminders
163. The directors shall comply with the Mowing provisions of the Act or the Corporations Registration Act (Nova
Scotia) where indicated:
(1) Keep a current register of shareholders (Section 42).
(2) Keep a current register of directors, officers and managers, send to the Registrar a copy thereof and notice of all
changes therein (Section 98).
(3) Keep a current register of holders of bonds, debentures and other securities (Section 111 and Third Schedule).
(4) Call a general meeting every year within the proper time (Section 83). Meetings must be held not later than 15
months after the preceding general meeting.
(5) Send to the Registrar copies of all special resolutions (Section 88).
(6) Send to the Registrar notice of the address of the Company's Office and of all changes in such address (Section
79).
(7) Keep proper minutes of all shareholders' meetings and directors' meetings in the Company's minute book kept at
the Company's Office (Sections 89 and 90).
(8) Obtain a certificate under the Corporations Registration Act (Nova Scotia) as soon as business is commenced.
(9) Send notice of recognized agent to the Registrar under the Corporations Registration Act (Nova Scotia).
Dated at Halifax, Nova Scotia the 22
nd
day of September, 2006.
Halifax, Nova Scotia
SEP, 22 2006.
FILED ELECTRONICALLY
in the computer records maintained by the Registry of Joint Stock Companies
STEWART MCKELVEY STIRLING SCALES
Annex 1
3147014 Nova Scotia Company (the "Company")
COMMON SHARES
1. Voting Rights: Each holder of common shares shall be entitled to receive notice of and to attend all meetings of
shareholders of the Company and to vote thereat, except meetings at which only holders of a specified class of shares
(other than common shares) or specified series of shares are entitled to vote. At all meetings of which notice must be
given to the holders of the common shares, each holder of common shares shall be entitled to one vote in respect of
each common share held by him or her.
2. Dividends'. The holders of the common shares shall be entitled, subject to the rights, privileges, restrictions and
conditions attaching to any other class of shares of the Company, to receive any dividend declared by the Company. For
greater certainty, dividends may be declared to holders of any or all other classes of shares of the Company to the
exclusion of the holders of the common shares.
3. Rights on Dissolution: The holders of the common shares shall be entitled, subject to the rights, privileges, restric-
tions and conditions attaching to any other class of shares of the Company, to receive the remaining property of the
Company on a liquidation, dissolution or winding-up of the Company, whether voluntary or involuntary.
PREFERRED SHARES.
1. Ranking: The preferred shares shall rank senior to any other shares of the Company in respect of repayment of
capital.
2. Dividends: The holders of the preferred shares shall, in priority to the common shares, be entitled to receive and
the Company shall pay thereon, as and when declared by the directors out of the moneys of the Company properly
applicable to the payment of dividends, a monthly, non-cumulative, cash dividend at a rate being a percentage of the price
at which the first issued preferred shares were issued (the "Redemption Amount" thereof) per share per annum, which
percentage will be determined by the directors at the time of the first issue of preferred shares or so soon there after
as may be. No dividend may be declared or paid on any other class of shares in respect of any month unless and until the
dividend payable hereunder has been declared and paid on the preferred shares.
3. No Voting Rights: Subject to the terms of the Third Schedule to Nova Scotia Companies Act (the "Act")» the holders
of the preferred shares shall not, as such, be entitled to receive notice of or to attend or vote at meetings of the
shareholders of the Company.
141244
L
U X E M B O U R G
4. Rights on Dissolution: In the event of the liquidation, dissolution or winding-up of the Company whether voluntary
or involuntary, the holders of the preferred shares shall be entitled to receive in respect of each such share, before any
distribution of any part of the assets of the Company among the holders of the common shares and any other class of
shares of the Company ranking junior to the preferred shares, an amount equal to the Redemption Amount of the
preferred shares held, together with any dividends declared but unpaid upon such shares, and no more.
5, Redemption at the Option of the Company: Subject to the Act, the Company shall, at its option, be entitled to
redeem at any time or times all or any part of the preferred shares registered in the name of any holder of any such
preferred shares on the books of the Company with or without the consent of such holder by giving notice in writing to
such holder specifying:
(a) that the Company desires to redeem all or any part of the preferred shares registered in the name of such holder;
and
(b) if part only of the preferred shares registered in the name of such holder is to be redeemed, the number thereof
to be so redeemed; and
(c) the business day (in this paragraph referred to as the "Redemption Date") on which the Company desires to redeem
such preferred shares. Such notice shall specify a Redemption Date which shall not be less than thirty (30) days after the
date on which the notice is given by the Company or such shorter period of time as the Company and the holder of any
such preferred shares may agree; and
(d) the place of redemption.
The Company shall, on the Redemption Date, redeem such preferred shares by paying to the holder(s) thereof, or
distributing properties the value of which is equal to the Redemption Amount thereof together with any dividends declared
but unpaid upon such shares (which amount shall be, when such term is used in connection with the preferred shares,
the "Redemption Price") on presentation and surrender of the certiftcate(s) for the preferred shares so called for re-
demption at such place as may be specified in such notice. The certiflcate(s) for such preferred shares shall thereupon be
cancelled and the preferred shares represented thereby shall thereupon be redeemed. Such payment shall be made by
delivery to such holder of a cheque payable in the amount of the aggregate Redemption Price for the preferred shares
to be redeemed or payment by such other method as may be acceptable to the holder. From and after the Redemption
Date the holder thereof shall not be entitled to exercise any of the rights of holders of preferred shares in respect thereof
unless payment of such Redemption Price is not made on the Redemption Date, or on presentation and surrender of the
certificate(s) for the preferred shares so called for redemption, whichever is later in which case the rights of the holder
of such preferred shares shall remain unaffected until payment in full of the Redemption Price.
Where at any time some but not all of such preferred shares are to be redeemed the preferred shares to be redeemed
shall be selected by lot in such manner as the board of directors determines, or as nearly as may be in proportion to the
number of preferred shares registered in the name of each holder, or in such other manner as the board of directors
determines.
Référence de publication: 2014134954/853.
(140152644) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2014.
Crown Premium Private Equity VI Master S.C.S,SICAV-FIS, Société à responsabilité limitée sous la forme
d'une SICAF - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 2, place François-Joseph Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 189.730.
STATUTEN
<i>Auszüge des Gesellschaftsvertrages (der "Gesellschaftsvertrag") der Gesellschaft, vom 18. August 2014i>
1. Gesellschafter, die unmittelbar und gesamtschuldnerisch haften. CROWN PREMIUM GP VI S.à r.l., eine Gesellschaft
mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), gegründet und bestehend unter den Gesetzen des Großher-
zogtums Luxemburg, mit eingetragenem Gesellschaftssitz in 2, Place François-Joseph Dargent, L-1413 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg, mit eingetragenem Stammkapital in Höhe von zwölftausendsechshundert Euro (EUR 12.600),
deren Eintragung im Luxemburger Handels-und Gesellschaftsregister anhängig ist (die "Komplementärin").
2. Name, Zweck der Gesellschaft, Sitz, Geschäftsjahr.
(i) Name
Die Gesellschaft heißt: "CROWN PREMIUM Private Equity VI Master S.C.S., SICAV-FIS" (die "Gesellschaft" oder
„CROWN PREMIUM VI Master S.C.S.")
(ii) Zweck der Gesellschaft
Der Zweck der CROWN PREMIUM VI Master S.C.S. besteht in der Anlage ihres Vermögens in Beteiligungen an
Unternehmen oder Gesellschaften, deren Zweck das Halten von Anteilen an anderen Unternehmen oder Gesellschaften
ist (Private Equity Fonds). Die Beteiligungen der Gesellschaft erfolgen mit dem Zweck, die Anlagerisiken zu streuen und
141245
L
U X E M B O U R G
ihren Gesellschaftern die Ergebnisse aus der Anlagetätigkeit zugutekommen zu lassen. Die Grundsätze der Anlagepolitik
der Gesellschaft werden im Emissionsdokument der CROWN PREMIUM VI Master S.C.S. beschrieben.
In den Grenzen des vorstehenden Gesellschaftszweckes kann CROWN PREMIUM VI Master S.C.S. jegliche Maßnah-
men ergreifen und Transaktionen ausführen, die CROWN PREMIUM VI Master S.C.S. für die Erfüllung und Ausführung
dieses Gesellschaftszweckes für nützlich erachtet, vorausgesetzt, die Anforderungen des Gesetzes von 2007 werden
berücksichtigt.
(i) Sitz
Der Sitz der Gesellschaft ist in 2, Place François-Joseph Dargent, L-1413 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
(ii) Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr wird das Kalenderjahr sein. Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 18. August 2014
und endet am 31. Dezember 2014.
3. Wahl des Geschäftsführers und Zeichnungsbefugnisse. Die Geschäftsführung der Gesellschaft obliegt der Komple-
mentärin.
Die Komplementärin wird die Gesellschaft, soweit diese Befugnis nicht durch den Gesellschaftsvertrag oder das Lu-
xemburger Gesetz vom 10. August über Handelsgesellschaften auf die Generalversammlung übertragen wurde, umfassend
vertreten.
Die Komplementärin wird die Gesellschaft auf Basis der Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages oder in sonstiger
Weise bestmöglich im Interesse der Gesellschaft führen. Jede Haftung der Komplementärin gegenüber der Gesellschaft
wird auf Fälle des Vorsatzes (dol) und der groben Fahrlässigkeit (négligence grave) beschränkt.
Die Gesellschaft wird durch die Unterschrift der Komplementärin, durch welche die Gesellschaft repräsentiert wird,
rechtskräftig gegenüber Dritten verpflichtet.
4. Anfang und Enddatum der Gesellschaft. Die Laufzeit der CROWN PREMIUM VI Master S.C.S. beginnt mit der
Errichtung der Gesellschaft und endet mit Ablauf des 31. Dezember 2029, es sei denn, die Laufzeit wurde durch einen
Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter, welcher in und mit der für eine Änderung des Gesellschaftsver-
trages erforderlichen Form und Mehrheit gefasst werden soll oder in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des
Artikels 26, verkürzt oder verlängert.
18. August 2014.
CROWN PREMIUM Private Equity VI Master S.C.S., SICAV-FIS, vertreten durch
CROWN PREMIUM GP VI S.à r.l.
Signature
<i>Die Bevollmächtigtei>
Référence de publication: 2014134183/54.
(140152405) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2014.
Temrex S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 296-298, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 181.738.
L'an deux mille quatorze, le douze août.
Par devant nous, Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg,
A comparu:
Monsieur Richard BATESON, Chef d’entreprise, né le 11 février 1952 à La Tronche (France) demeurant à F-75 007
Paris, 90, rue de Grenelle (France),
ici représenté par Monsieur Jean-Philippe MERSY, employé, demeurant professionnellement à L-2529 Howald, 45 rue
des Scillas, en vertu d’une procuration lui délivrée, laquelle après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire et le
notaire instrumentant, restera annexée aux présentes.
Laquelle personne comparante a, par sa mandataire, requis le notaire instrumentant, d’acter ce qui suit:
La comparante est l’associée unique de Temrex S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois,
ayant son siège social à L-1940 Luxembourg, 296-298, route de Longwy, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg, sous le numéro B 181738, constituée suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence
à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg) en date du 31 octobre 2013, publié au Mémorial C numéro 3320 du 31
décembre 2013, dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis,
ayant un capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cent-vingt-cinq (125) parts
sociales de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Que la comparante, agissant en sa qualité d’associée unique de la Société, s’est réunie en assemblée générale extraor-
dinaire, et a pris les résolutions suivantes:
141246
L
U X E M B O U R G
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale CONSTATE que la société Temrex S.à r.l., (ci-après la «Société Absorbante») est devenue
l’associée unique de FABRICOLA S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1931
Luxembourg, 13-15, Avenue de la Liberté, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le
numéro B 94744, (ci-après la «Société Absorbée»).
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale DÉCIDE d’approuver, après examen des documents prescrits par l’article 267 de la Loi, telle que
modifiée, le projet commun de fusion entre la Société Absorbée et la Société Absorbante arrêté tel que reçu le 27 juin
2014 par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), publié au Mémorial
C numéro 1804 du 11 juillet 2014.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale DÉCIDE de fusionner la Société Absorbée par voie d’absorption par la Société Absorbante en
conformité avec l’article 278 et suivants de la Loi sans émission d’actions nouvelles de la Société Absorbante, étant entendu
que (i) toutes les parts sociales de la Société Absorbée seront annulées suite au transfert de tous les actifs et passifs de
la Société Absorbée, rien excepté, ni réservé, au jour de la réalisation de ces fusions entraînant la dissolution automatique
de la Société Absorbée, laquelle dissolution ne sera suivie d’aucune opération de liquidation, et (ii) la fusion sera effective
d’un point de vue comptable et fiscal au 1
er
janvier 2014.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale RECONNAIT que la fusion sera définitivement réalisée suite à la décision concordante de l’as-
sociée unique de la Société Absorbée.
L’assemblée RECONNAIT de surcroît que la fusion sera effective d’un point de vue comptable et fiscal au 1
er
janvier
2014.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée générale DÉCIDE de déléguer tous pouvoirs au gérant de la Société Absorbée pour accomplir sous sa
signature individuelle tout ce qui est nécessaire ou utile en vue de la mise en oeuvre des résolutions précédentes, y
compris la passation de tous les actes nécessaires au transfert d’actifs et de passifs tels que décidés en vertu des susdites
résolutions.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare attester conformément aux dispositions de l’article 271(2) de la Loi l’existence et la légalité
des actes et formalités incombant à la Société Absorbante et du projet commun de fusion entre la Société Absorbante
et la Société Absorbée.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués
à 900,- EUR.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte fait et passé à Howald, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire soussigné par leur nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire soussigné, le présent acte.
Signé: Jean-Philippe MERSY, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 18 août 2014. Relation GRE/2014/3326. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2014132809/66.
(140150176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2014.
Filomena S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 84.208.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014133081/9.
(140151138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2014.
141247
L
U X E M B O U R G
International Shipowners Reinsurance Company S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 8.848.
L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES du 25 juillet 2014 a renouvelé et élu pour un terme d'un an les
mandats des administrateurs et le délégué à la gestion journalière, les personnes nommées dans le relevé en annexe et a
élu PricewaterhouseCoopers Société Coopérative, 400 Route d'Esch, L-1014 Luxembourg, comme réviseur d'entrepri-
ses, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale des actionnaires de l'an 2015 ou jusqu'à l'élection de leurs
remplaçants.
Luxembourg, le 18 août 2014.
International Shipowners
Reinsurance Company S A
Philip Anthony ASPDEN
<i>General Manager/Administrateuri>
CONSEIL D'ADMINISTRATION - Date de nomination 25 juillet 2014.
Durée du mandat déterminé jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2015.
Nom
Date de naissance Lieu de naissance Pays de naissance Adresse
AAGAARD-SVENDSEN Birgit 29.02.1956
Aalborg
Danemark
Christian Winthers Vej 21b
DK-2800 Kongens Lyngby,
Danemark
AL-OTAIBI Mohammad Omair 18.11.1963
Riyadh
Arabie Saoudite 569 Sitteen Street, Bahri
Building, Malaz Area
11492 Riyadh,
Arabie Saoudite
ASPDEN Philip Anthony
22.07.1945
Eastbourne
Grande Bretagne rue de Trintange, 12
L-5465 Waldbredimus
BREVET Thierry Louis Joseph
13/05/1959
Annecy
France
rue Marie-Adélaïde, 29
L-2128 Luxembourg
LESTER Jonathan Robert
26.03.1947
London
Grande Bretagne The Old School House, 30
Brook, Godalming
Surrey GU8 5UQ
Grande Bretagne
LINDSAY Robert Andrew
26.05.1963
Rochester,
New York,
Etats Unis
Brambles, Shoreham Road
TN14 5RL Otford, Kent
Grande Bretagne
LORENZ-MEYER Paul Robert
Lorenz
30.01.1962
Hambourg
Allemagne
Parkallee, 64
D-201434 Hamburg,
Allemagne
LOS Matheos Tassos
26.06.1944
Vrontados
Grèce
Portland Place, 82
London W1B 1NS
Grande Bretagne
MEYER Jean
27.12.1945
Luxembourg
Luxembourg
Bei der Aarnescht, 41
L-6969 Oberanven
PETALAS Tatiana
15.03.1973
Genève
Suisse
Avenue Princess Grace, 7
98000 Monte Carlo,
Monaco
WILLIAMS Richard Bradbury
23.06.1968
Belfast, Ireland
Grande Bretagne Woodside, 40
SW19 7AG, Wimbledon
Londres
Grande Bretagne
GENERAL MANAGER (DELEGUE A LA GESTION JOURNALIERE)
ASPDEN Philip Anthony
Adresse Privé: rue de Trintange, 12, L-5465 Waldbredimus
PERSONNE(S) CHARGE DU CONTRÔLE DES COMPTES:
REVISEUR D'ENTREPRISE
PricewaterhouseCoopers Société Coopérative - RCS B65477
Siège social: route d'Esch, 400, L-1014 Luxembourg
141248
L
U X E M B O U R G
Luxembourg le 18 août 2014.
Certifié exacte
Philip Anthony ASPDEN
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2014132889/64.
(140150533) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2014.
Gavento S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 129.443.
L'an deux mille quatorze, le onzième jour du mois d'août;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné;
S'est réunie
l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l’“Assemblée”) de la société anonyme qualifiée comme société
de gestion de patrimoine familial régie par les lois du Luxembourg “GAVENTO S.A., SPF”, établie et ayant son siège social
à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
section B, sous le numéro 129443, (la “Société”), constituée originairement sous la dénomination sociale de “GAVENTO
S.A.”, suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), en
date du 18 juin 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1748 du 18 août 2007,
et dont les statuts (les “Statuts”) ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant:
- en date du 20 décembre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 286 du 2 février
2012, contenant notamment la transformation en société de gestion de patrimoine familial (“SPF”) et l’adoption de la
dénomination sociale actuelle;
- en date du 7 mars 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1019 du 20 avril 2012;
- en date du 25 avril 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1358 du 1
er
juin 2012.
L'Assemblée est présidée par Madame Virginie PIERRU, employée, demeurant professionnellement à L-1466 Luxem-
bourg, 12, rue Jean Engling.
La Présidente désigne Madame Monique GOERES, employée, demeurant professionnellement à L-1466 Luxembourg,
12, rue Jean Engling, comme secrétaire.
L'Assemblée choisit Monsieur Christian DOSTERT, employé, demeurant professionnellement à L-1466 Luxembourg,
12, rue Jean Engling, comme scrutateur.
Le bureau ayant ainsi été constitué, la Présidente a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:
A) Que la présente Assemblée a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Dissolution de la Société et décision de mettre la Société en liquidation volontaire;
2. Décharge accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société pour l’exercice de leurs
mandats respectifs;
3. Nomination de la société “Faber & Welding S.à r.l.”, en tant que liquidateur en vue de la liquidation volontaire de
la Société;
4. Détermination des pouvoirs du liquidateur et détermination de la procédure de mise en liquidation de la Société;
5. Divers.
B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre de actions possédées par chacun d'eux, sont
portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux
représentés, les membres du bureau de l’Assemblée et le notaire instrumentant.
C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées “ne varietur” par les membres du bureau de l’Assemblée
et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.
D) Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés,
déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l’ordre du jour préalablement à cette Assemblée et
renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.
E) Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement sur les objets portés à l’ordre du jour.
Ensuite l’Assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
141249
L
U X E M B O U R G
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée décide avec effet immédiat de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation volontaire.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide d'accorder décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société pour
l’exercice de leurs mandats respectifs jusqu'à la date des présentes.
L’Assemblée décide de reconnaître, approuver, ratifier et reprendre au compte de la Société tous les actes pris par
les administrateurs de la Société pour la période débutant à la date de constitution de la Société et se terminant à ce jour
et de renoncer à son droit d’exercer tout recours à l’encontre des administrateurs résultant de leur gestion de la Société.
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée décide de nommer la société à responsabilité limitée constituée et existant sous les lois du Grand-Duché
de Luxembourg “Faber & Welding S.à r.l.”, établie et ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume
Kroll, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 168526, en tant que
liquidateur (le “Liquidateur”) de la Société.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée décide de conférer au Liquidateur les pouvoirs les plus étendus, prévus par les articles 144 et suivants
de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée (la “Loi”).
L'Assemblée décide également d'instruire le Liquidateur, dans la limite de ses capacités et selon les circonstances, afin
qu'il réalise l’ensemble des actifs et solde les dettes de la Société.
L'Assemblée décide que le Liquidateur sera autorisé à signer tous actes et effectuer toutes opérations au nom de la
Société, y compris les actes et opérations stipulés dans l’article 145 de la Loi, sans autorisation préalable de l’assemblée
générale des actionnaires. Le Liquidateur pourra déléguer ses pouvoirs pour des opérations spécifiques ou d'autres tâches
à une ou plusieurs personnes ou entités, tout en conservant seul la responsabilité des opérations et tâches ainsi déléguées.
L'Assemblée décide également de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur, pour le compte de la Société en liqui-
dation, afin qu'il exécute, délivre, et effectue toutes obligations relatives à tout contrat ou document requis pour la
liquidation de la Société et à la liquidation de ses actifs.
L'Assemblée décide en outre de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur afin d'effectuer, à sa discrétion, tous
versements d'avances en numéraire ou en nature des boni de liquidation aux actionnaires de la Société, conformément
à l’article 148 de la Loi.
Aucun autre point n'étant porté à l’ordre du jour de l’Assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés
ne demandant la parole, la Présidente a ensuite clôturé l’Assemblée.
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à mille cinquante euros.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits
comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: V. PIERRU, M. GOERES, C. DOSTERT, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 12 août 2014. LAC/2014/38233. Reçu douze euros 12,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Luxembourg, le 27 août 2014.
Référence de publication: 2014133118/91.
(140151487) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2014.
Redcor Reaseguros S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny.
R.C.S. Luxembourg B 153.252.
L'an deux mille quatorze, le trois juillet.
Par devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
A comparu:
«RED ELECTRICA CORPORACION S.A.», une société existante et gouvernée par les lois de l’Espagne avec siège
social établi à Paseo Conde de los Gaitanes, 177 à E-28109 Alcobendas Madrid (RC Madrid N°A78003662),
141250
L
U X E M B O U R G
ici représentée par Monsieur Rafael GARCIA DE DIEGO BARBER, demeurant professionnellement à Paseo Conde
de los Gaitanes, 177 à E-28109 Alcobendas Madrid, en vertu d'une procuration donnée le 26 décembre 2013.
Laquelle procuration, après avoir été paraphée «ne varietur» par le mandataire de la comparante et le notaire instru-
mentant, restera annexée au présent acte pour les besoins de 1'enregistrement.
Laquelle comparante, représentée comme ci-avant, est la seule et unique actionnaire («l’Actionnaire Unique») de la
société anonyme «REDCOR REASEGUROS S.A.» (la "Société»), ayant son siège social à L-1946 Luxembourg, 26, rue
Louvigny, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 17 mai 2010, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations numéro 1427 le 13 juillet 2010,
immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 153.252.
L’Actionnaire Unique, représentée comme ci-avant et représentant l’intégralité du capital social, a requis le notaire
instrumentant d’acter les résolutions contenues dans l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Augmentation du capital social d'un montant de un million trois cent mille euros (1.300.000.- EUR), afin de le porter
de son montant actuel de trois millions deux cent mille euros (EUR 3.200.000) représenté par mille (1.000) actions de
trois mille deux cents euros (EUR 3.200) chacune, à quatre millions cinq cent mille euros (4.500.000,-EUR), sans création
ni émission de nouvelles actions, mais par augmentation de la valeur nominale des actions.
2. Modification de la valeur nominale des actions afin que le capital social soit divisé en mille (1.000) actions d’une
valeur nominale de quatre mille cinq cents euros (4.500,-EUR) chacune.
3. Modification subséquente de l’article 5 des statuts.
4. Divers.
<i>Première résolution:i>
L’Actionnaire Unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de un million trois cent mille
euros (1.300.000.- EUR), afin de le porter de son montant actuel de trois millions deux cent mille euros (EUR 3.200.000)
représenté par mille (1.000) actions de trois mille deux cents euros (EUR 3.200) chacune, à quatre millions cinq cent mille
euros (4.500.000,-EUR), sans création ni émission de nouvelles actions mais par augmentation de la valeur nominale des
actions.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à ce qui précède, l’Actionnaire Unique décide d’augmenter la valeur nominale des actions d’un montant de mille
trois cents euros (1.300,- EUR), afin que le capital social soit divisé en mille (1.000) actions d’une valeur nominale de
quatre mille cinq cents euros (4.500,-EUR) chacune.
<i>Libérationi>
L’augmentation de la valeur nominale des actions a été réalisée moyennant un apport en numéraire de sorte que le
montant de un million trois cent mille euros (1.300.000,-EUR) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été
justifié au notaire instrumentant qui le constate.
<i>Troisième résolution:i>
A la suite de la résolution qui précède, l’Actionnaire Unique décide de modifier l’article 5 des Statuts de la Société
comme suit:
« Art. 5. Le capital social est fixé à quatre millions cinq cent mille euros (4.500.000,-EUR) représenté par mille (1.000)
actions d'une valeur nominale de quatre mille cinq cents euros (4.500,-EUR) chacune.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société,
ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, est évalué à deux mille trois cent trente-huit euros (2.338,-EUR).
DONT ACTE, fait et passé, à la date mentionnée en tête des présentes à Luxembourg
Le notaire instrumentant déclare que le présent acte est établi en langue française.
Le document a été lu au mandataire de la comparante, connu du notaire par son nom, prénom, état civil et domicile,
celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. GARCIA DE DIEGO BARBER, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 08 juillet 2014. Relation: LAC/2014/31791. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR COPIE CONFORME, délivrée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.
141251
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 25 août 2014.
Référence de publication: 2014133938/63.
(140151892) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2014.
Dal Futura S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9353 Bettendorf, 23, Freschegaas.
R.C.S. Luxembourg B 172.863.
DISSOLUTION
In the year two thousand and fourteen, on the twenty first of August.
Before Maître Edouard DELOSCH, notary, residing in Diekirch Grand Duchy of Luxembourg.
It appeared:
Mr. Daniel NIETO VELAZQUEZ, Engineer, born on 1
st
April 1975, in Sevilla (Spain), residing in L-9353 Bettendorf,
23, Freschegaas.
Such appearing party has declared and requested the notary to act:
I.- That the company «Dal Futura S.à r.l.» a "société à responsabilité limitée", established and having its registered office
at L-9353 Bettendorf, 23, Freschegaas, registered in the Luxembourg Register of Commerce and Companies, section B,
number 172.863, has been incorporated pursuant to a deed of Maître Edouard DELOSCH, notary residing in Diekirch,
of 14 November 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, dated 20 December 2012,
number 3065, the articles of incorporation of the Company have for the last time been amended following a deed of the
undersigned notary, of 5
th
July 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2294 on
September 18, 2013 (here after "the Company");
II.- That the corporate capital of the Company is fixed at twelve thousand four hundred Euro (EUR 12,400) divided in
one hundred (100) shares with a nominal value of one hundred twenty-four Euro (EUR 124.-) each, and each of them
entirely paid up in cash;
III.- That the appearing party declares to have full knowledge of the Articles of Incorporation and the financial standing
of the Company "Dal Futura S.à r.l.", prenamed;
IV.- That the appearing party has acquired all of the one hundred shares of the Company and, as a sole shareholder,
has decided to proceed with the dissolution and the immediate liquidation of said Company.
V.- That the appearing party, assuming the role of liquidator of the Company, declares that the business activity of the
Company has ceased, that the known liabilities of the Company have been settled or fully provided for, that the appearing
party as sole shareholder is vested with all the assets and hereby expressly declares that it will take over and assume all
outstanding liabilities (if any) of the Company, in particular those hidden or any known but unpaid and any as yet unknown
liabilities of the Company before any payment to itself.
VI.- That, consequently, the Company be and hereby is liquidated and the liquidation is closed.
VII.- That the appearing party fully discharges the manager for the due performance of his duty up to this date.
VIII.- That the records and documents of the Company will be kept for a period of five (5) years at the former registered
office of the dissolved Company, being L-9353 Bettendorf, 23, Freschegaas.
IX.- That all the Company's shares in circulation and if necessary the register of shareholders of the Company are
cancelled.
X.- That the appearing party commits itself to pay the costs of the present deed.
The undersigned notary who understands and speaks English, records that on request of the above appearing person,
the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing person and
in case of discrepancies between the English and the French text, the English text will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Diekirch, on the day named at the beginning of this document.
The document after having been read to the appearing person, said appearing person signed together with the notary,
the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux quatorze, le vingt et unième jour du mois d'août.
Par-devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch (Grand-Duché du Luxembourg),
a comparu:
Monsieur Daniel NIETO VELAZQUEZ, ingénieur, né le premier avril 1975, à Seville (Espagne), demeurant à L-9353
Bettendorf, 23, Freschegaas, ci-après dénommé "le mandant".
Laquelle partie comparante a déclaré et a requis le notaire instrumentant d'acter:
141252
L
U X E M B O U R G
I.- Que la société "Dal Futura S.à r.l», une société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social au L-9353
Bettendorf, 23, Freschegaas, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro
B 172.863, a été constituée suivant acte reçu par le notaire Edouard DELOSCH en date du 14 novembre 2012, lequel
acte fut publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 3065 du 20 décembre 2012; dont les statuts
ont pour la dernière fois été modifiés suivant un acte reçu par le notaire soussigné en date du 5 juillet 2013, publié dans
le Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations numéro 2294, le 18 septembre 2013 (ci-après "la Société");
II.- Que le capital social souscrit de la Société s'élève actuellement à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400.-)
divisé en cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-quatre euros (EUR 124.-) et chaque parts sociales
étant intégralement libérée en numéraire;
III.- Que le comparant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société "Dal
Futura S.à r.l.», précitée.
IV.- Que le comparant est devenu propriétaire de toutes les cent (100) parts sociales de la susdite Société et qu'en
tant qu'associé unique il a décidé de procéder à la dissolution anticipée et à la liquidation immédiate de la susdite Société.
V.- Que le comparant, assumant le rôle de liquidateur de la Société, déclare que l'activité de la Société a cessé, que le
passif connu de la Société a été payé ou dûment provisionné, que le comparant en tant qu'associé unique est investi de
tout l'actif et qu'il s'engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à
charge de la Société et tout passif impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne.
VI.- Que, partant, la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée.
VII.- Que décharge pleine et entière est accordée au gérant de la Société dissoute pour l'exécution de son mandat
jusqu'à ce jour.
VIII.- Que les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq (5) ans à l'ancien siège social
de la Société dissoute, à L-9353 Bettendorf, 23, Freschegaas.
IX.- Que toutes les parts sociales en circulation, et le cas échéant le registre des associés, de la Société sont annulés.
X.- Que le comparant s'engage à prendre à sa charge tous les frais et honoraires en relation avec le présent acte.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne com-
parante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la requête de la même personne comparante
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Diekirch, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, ladite personne comparante a signé avec le
notaire instrumentant le présent acte.
Signé: D. NIETO VELAZQUEZ, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 25 août 2014. Relation: DIE/2014/10721. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): RIES Christian.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Diekirch, le 26 août 2014.
Référence de publication: 2014134189/88.
(140152526) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2014.
HW Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 359, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 134.265.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 8 août 2014 à Luxembourg.i>
Il résulte du procès-verbal de ladite assemblée générale des actionnaires qu'à l'unanimité des voix, l'assemblée a pris
les résolutions suivantes:
1. Les mandats d'Administrateur et de Président du Conseil d'Administration de Monsieur Eric WATLET, adminis-
trateur de sociétés, demeurant à 11, rue Moreau, B-6724 Orsinfaing, sont renouvelés jusqu'à l'issue de l'assemblée
générale de 2019 statuant sur les comptes clôturés au 31/12/2018;
2. Le mandat d'Administrateur de Monsieur Arnaud WATLET, administrateur de sociétés, demeurant à 215, Vieille
Rue, B-6769 Gérouville, est renouvelé jusqu'à l'issue de l'assemblée générale de 2019 statuant sur les comptes clôturés
au 31/12/2018;
3. Le mandat d'Administrateur de Madame Martine FLAMION, employée privée, demeurant à 11, rue Moreau, B-6724
Orsinfaing, est renouvelé jusqu'à l'issue de l'assemblée générale de 2019 statuant sur les comptes clôturés au 31/12/2018;
4. Le mandat d'Administrateur de Madame Catherine GILLES, employée privée, demeurant à 215, Vieille Rue, B-6769
Gérouville, est renouvelé jusqu'à l'issue de l'assemblée générale de 2019 statuant sur les comptes clôturés au 31/12/2018;
141253
L
U X E M B O U R G
5. L'assemblée a pris bonne note de la démission au terme de l'exercice précédent de son mandat de Commissaire
aux Comptes de la société The Clover SA, sise à L-8399 Windhof, 6, rue d'Arlon;
6. La société Ecofi Sàrl, sise à L-8366 Hagen, 1, rue de Steinfort, est nommée en tant que Commissaire aux Comptes,
en remplacement. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale de 2019 statuant sur les comptes clôturés au
31/12/2018.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
HW Invest S.A.
Signature
<i>Le Conseil d'Administrationi>
Référence de publication: 2014132497/30.
(140149971) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2014.
Aardvark Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 8.935.
Les comptes annuels au 30 septembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014132920/10.
(140151159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2014.
Active Solutions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 189.755.
STATUTS
L'an deux mille quatorze, le cinquième jour du mois d'août;
Pardevant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
ONT COMPARU:
1) La société par actions simplifiée constituée et existant sous les lois de France “Able Technologies”, établie et ayant
son siège social à F-06800 Cagnes-sur-Mer, 80, avenue des Chênes, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
auprès du Tribunal de Commerce d'Antibes sous le numéro 529 209 314; et
2) La société par actions simplifiée constituée et existant sous les lois de France “HEMAJETT”, établie et ayant son
siège social à F-06570 Saint-Paul, 950, chemin de Saint-Etienne, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés auprès
du Tribunal de Commerce d'Antibes sous le numéro 529 206 112.
Les parties comparantes sont ici représentées par Monsieur Christian DOSTERT, clerc de notaire, demeurant pro-
fessionnellement à L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling, (le “Mandataire”), en vertu de deux procurations sous seing
privé lui délivrées; lesquelles procurations, après avoir été signées “ne varietur” par le Mandataire et le notaire instru-
mentant, resteront annexées au présent acte afin d'être enregistrées avec lui.
Lesquelles parties comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi
qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elles déclarent constituer par les présentes et dont les statuts
sont arrêtés comme suit:
Titre I
er
. - Dénomination - Objet - Durée - Siège social
Art. 1
er
. Il est formé par la présente, entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui
pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée dénommée “Active Solutions S.à r.l.”, (ci-après la
“Société”), laquelle sera régie par les présents statuts (les “Statuts”) ainsi que par les lois respectives et plus particuliè-
rement par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Art. 2. La Société a pour objet la recherche, le développement et la protection intellectuelle de hardware, de logiciel
et de solutions innovantes d'interactivité associant affichage, appareils mobiles et réseaux sociaux.
La Société pourra acquérir par voie de participation, de prise ferme ou d'option d'achat, tous brevets, marques, licences,
marques de service, savoir-faire, ainsi que tous autres droits industriels, commerciaux ou de propriété intellectuelle, et
plus généralement les détenir et accorder des licences, sous-licences, les vendre ou en disposer, en tout ou partie, aux
conditions que la Société jugera appropriées et sous-traiter la gestion et le développement de ces droits, marques, brevets
et licences et obtenir et faire tous enregistrements requis à cet effet.
141254
L
U X E M B O U R G
La Société pourra également prendre toute action nécessaire pour protéger les droits afférant aux brevets, marques,
licences, marques de service, savoir-faire, et autres droits industriels, commerciaux ou de propriété intellectuelle, aux
sous-licences et droits similaires contre les violations des tiers.
La Société pourra en outre effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de
participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et
le développement de ces participations.
La Société pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et
à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au
développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option
d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement,
faire mettre en valeur ces affaires et brevets.
L'objet de la Société est également l'achat, la vente, la gestion et la location de tous immeubles, bâtis ou non bâtis, tant
au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit.
La Société pourra, dans les limites fixées par la Loi, accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous
concours, prêts, avances ou garanties.
Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter
caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.
La Société prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelcon-
ques, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent et qui sont susceptibles de
promouvoir son développement ou extension.
La Société pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immo-
bilières au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en
partie, à son objet social.
La Société pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou
en association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.
Art. 3. La durée de la Société est illimitée.
Art. 4. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg). L'adresse du siège
social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision de la gérance.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une simple décision des associés
délibérant comme en matière de modification des statuts.
Par simple décision de la gérance, la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs
aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Titre II. - Capital social - Parts sociales
Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500,-EUR), représenté par mille (1.000) parts sociales
d'une valeur nominale de douze Euros et cinquante Cents (12,50 EUR) chacune, intégralement libérées.
Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l'article 199 de la
loi concernant les sociétés commerciales.
Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime
de tous les associés.
En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer dans les 30
jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.
Art. 7. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la Société.
Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des
scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la Société.
Titre III. - Administration et gérance
Art. 8. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment
par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
141255
L
U X E M B O U R G
Art. 9. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement repré-
senter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 10. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux Statuts doivent réunir la majorité des associés repré-
sentant les trois quarts (3/4) du capital social.
Art. 11. Lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les Statuts à l'assemblée
générale sont exercés par l'associé unique.
Les décisions prises par l'associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par
écrit.
De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la Société représentée par lui sont inscrits sur un procès-
verbal ou établies par écrit.
Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.
Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.
Art. 13. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.
Art. 14. Tout associé peut prendre au siège social de la Société communication de l'inventaire et du bilan.
Art. 15. Les produits de la Société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements
et charges, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-
ci ait atteint dix pour cent du capital social.
Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.
Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Titre IV. - Dissolution - Liquidation
Art. 17. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.
Titre V. - Dispositions générales
Art. 18. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application
partout où il n'y est pas dérogé par les Statuts.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2015.
<i>Souscription et libérationi>
Les Statuts ayant ainsi été arrêtés, les mille (1.000) parts sociales ont été souscrites comme suit:
1) La société “Able Technologies”, pré-désignée, sept cent cinquante parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
750
2) La société “HEMAJETT”, pré-désignée, deux cent cinquante parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250
Total: mille parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000
Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire, de sorte que la somme de douze mille cinq
cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant ayant dressé le présent acte déclare avoir vérifié que les conditions énumérées à l'article 183
de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales sont remplies et le constate expressément.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, est évalué à environ neuf cents euros.
141256
L
U X E M B O U R G
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt, les associés, représentant l'intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se
sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
1. Le siège social est établi à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
2. La société par actions simplifiée constituée et existant sous les lois de France “Able Technologies”, établie et ayant
son siège social à F-06800 Cagnes-sur-Mer, 80, avenue des Chênes, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
auprès du Tribunal de Commerce d'Antibes sous le numéro 529 209 314, est nommée gérante de la Société pour une
durée indéterminée.
3. La Société est valablement engagée en toutes circonstances et sans restrictions par la signature individuelle de la
gérante.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au Mandataire des parties comparantes, ès-qualités qu'il agit, connu du
notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, ledit Mandataire a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: C. DOSTERT, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 6 août 2014. LAC/2014/37343. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i>
(signé): Carole Frising.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Luxembourg, le 27 août 2014.
Référence de publication: 2014134646/155.
(140153139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2014.
Arianne Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 7, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 189.761.
STATUTES
In the year two thousand fourteen, on the thirteenth of August.
Before us Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Herald Properties S.à r.l. a company with its registered office and its principal place of business at 7 Avenue Gaston
Diderich, L-1420 Luxembourg,
here represented by Mrs. Rachel HAFEDH, employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a power of
attorney, given under private seal.
Said proxies, after having been signed “ne varietur” by the proxyholder of the appearing parties and by the undersigned
notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.
Such appearing parties, represented as above stated, have requested the undersigned notary, to state as follows the
articles of association of a private limited company, which is hereby incorporated.
Art. 1. There is formed by the present appearing parties mentioned above and all persons and entities who may become
shareholders in the future, a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed by
the laws pertaining to such an entity, and in particular the law dated 10
th
August, 1915 on commercial companies, as
well as by the present articles (hereafter the "Company").
Art. 2. The object of the Company is the acquisition, management, development and sale, for its own account, directly
or indirectly, of real estate of any nature or origin, whatsoever, located in Luxembourg or any other jurisdiction.
The object of the Company is further the acquisition of participations in any form whatsoever, by purchase, exchange
or in any other way undertakings and companies either Luxembourg or foreign entities as well as the management, control,
and development of these participations. The Company may also carry out the transfer of these participations by means
of sale, exchange or otherwise. The Company may further acquire by subscription, purchase, and exchange or in any
other manner any stock, shares and other securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments
and more generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever.
The Company may take any controlling or supervisory measures and carry out any operations which it may deem
useful in the accomplishment of its object; it may also accept any mandate as director in other companies in Luxembourg
or foreign, remunerated or not.
The Company may also acquire and develop all patents, trademarks and other intellectual and intangible rights as well
as any other rights connected to them or which may complete them.
141257
L
U X E M B O U R G
The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement only,
notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including the
proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other
company. It may also give guarantees and grant security interests in favour of third parties to secure its obligations or the
obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further mortgage, pledge,
transfer, encumber or otherwise hypothecate all or some of its assets.
The Company may generally employ any techniques and utilize any instruments relating to its investments for the
purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against
credit risk, currency fluctuations risk, interest rate fluctuations risk and others risks.
The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to
real estate or movable property, which directly or indirectly further or relate to its the above described objects."
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will have the name “Arianne Properties S.à r.l.”.
Art. 5. The registered office is established in Luxembourg-City.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders. The address of the registered office may be transferred within the town limits
by a simple resolution of the manager or, in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. The Company's subscribed share capital is fixed at TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED EUROS (EUR
12,500.-) represented by FIVE HUNDRED (500) shares having a nominal value of TWENTY FIVE EUROS (EUR 25.-) per
share each.
Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the shareholders
meeting, in accordance with article 14 of these articles of association.
Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to
the number of shares in existence.
Art. 9. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint
co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 10. In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the
requirements of article 189 of the law of 10
th
August, 1915 on commercial companies.
Art. 11. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the
shareholders will not bring the Company to an end.
Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed, revoked
and replaced by the general shareholder meeting, by a decision adopted by shareholders owning more than half of the
share capital.
In case of plurality of managers, the board of managers chooses among its members a chairman. Only a Luxembourg
Resident shall be designated as the Chairman. The first chairman may be appointed by the general meeting. In the case
the chairman is unable to carry out his duties, he is replaced by the manager designated to this effect by the board of
managers.
In dealing with third parties, the sole manager will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of
this article 12 shall have been complied with. In case of plurality of managers, such powers may only be exercised jointly
by any two managers of the Company unless delegated to a single manager further to a resolution of the board. All powers
not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders fall within the
competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers (acting as aforesaid).
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
signature of two members of the board of managers.
The general shareholders meeting, or the sole manager, or in case of plurality of managers, the board of managers
may delegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.
The general shareholders meeting, or the sole manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will
determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any
other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented.
141258
L
U X E M B O U R G
The meetings of the board of managers are convened by the chairman or by any two managers.
In case of plurality of managers, written notices of any meeting of the board of managers will be given to all managers,
in writing or by cable, telegram, telefax or telex, at least 24 hours in advance of the hour set for such meeting, except in
circumstances of emergency. This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they state
that they have been informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual meetings
held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers. Any
manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telefax or telex
another manager as his proxy. Managers may also cast their vote by telephone confirmed in writing. The board of managers
can deliberate or act validly only if at least the majority of its members are present or represented at a meeting of the
board of managers. Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing
in which case it shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager.
The date of such a resolution shall be the date of the last signature.
Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability
in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company in accordance with these articles
of association (including, for the avoidance of any doubt, article 12).
Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number
of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions
are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority of the
shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital, subject to the provisions of the law of 10
th
August, 1915, as amended.
An annual general meeting of the shareholder(s) shall be held at the registered office of the Company, or at such other
place in the municipality of its registered office as may be specified in the notice of meeting. Other general meetings of
the shareholder(s) may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.
Art. 15. The Company's year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December.
Art. 16. Each year, with reference to 31
st
December, the Company's accounts are established and the manager, or
in case of plurality of managers, the board of managers prepares an inventory including an indication of the value of the
company's assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amor-
tisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share
capital. The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding
in the Company. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay interim
dividends.
Art. 18. At the time of winding up the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
Art. 19. Reference is made to the provisions of the law of 10
th
August, 1915, as amended, for all matters for which
no specific provision is made in these articles of association.
<i>Subscription and paymenti>
All the five hundred (500) shares have been subscribed by Herald Properties S.à r.l., prenamed, and have been fully
paid up, so that the sum of twelve thousand and five hundred euros (EUR 12,500.-) corresponding to a share capital of
twelve thousand and five hundred euros (EUR 12,500.-) is forthwith at the free disposal of the Company, as has been
proved to the notary.
<i>Transitory provisioni>
The first financial year shall begin today and it shall end on 31
st
December, 2014.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be born by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately one thousand one hundred fifty euros (EUR 1,150.-).
<i>Extraordinary general meetingi>
Immediately after the incorporation, the shareholder representing the entire subscribed capital of the Company has
herewith adopted the following resolutions:
141259
L
U X E M B O U R G
1) The number of managers is set at two. The meeting appoints as managers of the Company for an unlimited period
of time:
a. Mrs. Rachel HAFEDH, manager, born on 22 March 1976 in Hayange (France), professionally residing in L-1420
Luxembourg, 7, Avenue Gaston Diderich;
c. Property and Finance Corporation S.à r.l., a company with its registered office and its principal place of business at
7 Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg,
2) The address of the registered office is established in L-1420 Luxembourg, 7, Avenue Gaston Diderich.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, Luxembourg, on the years and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder signed together with us,
the notary, the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille quatorze, le treize août.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
Herald Properties S.à r.l, une société constituée selon le droit du Grand Duché du Luxembourg, ayant son siège social
à L-1420 Luxembourg, 7, Avenue Gaston Diderich,
ici représentée par Madame Rachel HAFEDH, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu
d'une procuration donnée sous seing privé.
Lesdites procurations, après signature ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumen-
tant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Lesquelles comparantes, agissant en-dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser l'acte constitutif
d'une société à responsabilité limitée et dont les statuts ont été arrêtés comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes par les comparants et toutes les personnes qui pourraient devenir associés
par la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, et notamment celle du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (ci-après la «Société»).
Art. 2. La Société a pour objet l'acquisition, la gestion, le développement et la vente pour son propre compte, direc-
tement ou indirectement, de biens immobiliers de quelque nature ou origine que ce soit, situés au Luxembourg ou dans
tout autre pays.
L'objet social de la Société est également l'acquisition de participations sous quelque forme que ce soit, par achat,
échange ou de toute autre manière, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères ainsi que la gestion, le con-
trôle, la mise en valeur de ces participations. La Société pourra également acquérir par souscription, achat, et échange
ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt
et autres instruments de dette et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou
privée.
La Société pourra prendre toutes les mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toutes opérations qui peuvent
lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet; elle pourra également détenir des mandats d'administration d'au-
tres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, rémunérées ou non.
La Société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets, marques de fabrique et autres droits intellectuels
et incorporels ainsi que tous autres droits s'y rattachant ou pouvant les compléter.
La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder par
voie de placement privé, à l'émission de parts sociales et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de
créances. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des emprunts et/ou des
émissions d'obligations ou de valeurs, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toute autre société. La Société pourra consentir
des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou celles de ses filiales, sociétés
affiliées ou de toute autre société. La Société pourra aussi gager, nantir, grever, transférer, grever tout ou partie de ses
avoirs.
La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue
d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre le risque de crédit, les
fluctuations monétaires, fluctuations de taux d'intérêt et tout autre risque.
La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles, ainsi que toutes transactions
se rapportant à la propriété immobilière ou mobilière, qui directement ou indirectement favorisent ou se rapportent à
la réalisation de son objet tel que décrit ci-dessus.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
141260
L
U X E M B O U R G
Art. 4. La Société prend la dénomination de «Arianne Properties S.à r.l.».
Art. 5. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés. L'adresse
du siège social peut être transférée endéans les limites de la commune de Luxembourg par simple décision du gérant ou,
en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut ouvrir des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu'à l'étranger.
Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500,-)
représenté par CINQ CENTS (500) parts sociales d'une valeur nominale de VINGT CINQ EUROS (EUR 25,-) chacune.
Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l'associé unique sinon de l'assemblée
des associés, conformément à l'article 14 des présents statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l'actif social
ainsi que des bénéfices.
Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune
d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule
et même personne.
Art. 10. Toutes cessions de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres.
En cas de pluralité d'associés, les parts sociales peuvent être cédées, à condition d'observer les exigences de l'article
189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Art. 11. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique, sinon d'un des associés, ne mettent pas
fin à la Société.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un conseil
de gérance. Le ou les gérant(s) n'ont pas besoin d'être associés. Le ou les gérants sont désignés, révoqués et remplacés
par l'assemblée des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital social.
En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance élit parmi ses membres un président. Seul un résidant du Luxem-
bourg peut être élu comme président. Le premier président pourra être désigné par 1'assemblée générale. En cas
d'empêchement du président, le gérant désigné à cet effet par le conseil de gérance le remplace.
Vis-à-vis des tiers, le gérant unique a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances
et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l'objet social et sous réserve du respect des
dispositions du présent article 12. En cas de pluralité de gérants, ces pouvoirs sont conjointement exercés par deux
gérants de la Société, sauf s'ils ont été délégués à un gérant unique par une résolution du conseil de gérance.
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale des associés
sont de la compétence du gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, de la compétence du conseil de gérance
(agissant conformément aux dispositions susmentionnées).
En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et en cas de pluralité de
gérants, par la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance.
L'assemblée des associés, ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer
ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.
L'assemblée des associés, ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera la
responsabilité du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n'importe
quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.
En cas de pluralité de gérants, les décisions du conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants
présents ou représentés.
Le conseil de gérance se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux gérants.
En cas de pluralité de gérants, avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants par écrit
ou par câble, télégramme, télex ou télécopie, au moins 24 heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence.
On pourra passer outre cette convocation si les gérants sont présents ou représentés au conseil de gérance et s'ils
déclarent avoir été informés de l'ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil
de gérance se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil
de gérance. Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie
un autre gérant comme son mandataire. Les gérants peuvent également voter par appel téléphonique, à confirmer par
écrit. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente
ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil
de gérance peut également être prise par voie circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les
résolutions et signés par tous les membres du conseil de gérance sans exception. La date d'une telle décision sera la date
de la dernière signature.
141261
L
U X E M B O U R G
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société conformément aux présents statuts (y compris, afin de
dissiper toute ambiguïté, l'article 12).
Art. 14. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés.
En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de
parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.
En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées
par des associés représentant plus de la moitié du capital social.
Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que par l'accord de la majorité
des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la loi du 10 août
1915, telle que modifiée.
Une assemblée générale annuelle de l'associé unique ou des associés se tiendra au siège social de la Société ou à tout
autre endroit de la commune de son siège social défini dans la convocation à l'assemblée.
D'autres assemblées générales de l'associé unique ou des associés peuvent être tenues aux lieux et places indiqués
dans la convocation.
Art. 15. L'année sociale de la Société commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre.
Art. 16. Chaque année, au trente-et-un décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le conseil
de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.
Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire et du bilan.
Art. 17. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amor-
tissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde du bénéfice net est à la libre
disposition de l'assemblée générale. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra
décider de verser un dividende intérimaire.
Art. 18. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 19. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales de
la loi du 10 août 1915.
<i>Souscription et libérationi>
Les cinq cents (500) parts sociales ont été souscrites par Herald Properties S.à r.l., précitée, et ont été entièrement
payées, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500.-) correspondant à un capital social de douze
mille cinq cents euros (EUR 12.500.-) soit à la disposition de la Société, comme il a été justifié au notaire soussigné.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2014.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à approximativement à mille cent cinquante euros (EUR
1.150,-).
<i>Assemblée générale constitutivei>
Immédiatement après la constitution de la Société, les associés préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit
ont pris les résolutions suivantes:
1. Le nombre de gérant est fixé à deux. Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
a. Madame Rachel HAFEDH, gérante née le 22 mars 1976 à Hayange (France), demeurant professionnellement à L-1420
Luxembourg, 7, Avenue Gaston Diderich;
c. Property and Finance Corporation S.à r.l., une société constituée selon le droit du Grand Duché du Luxembourg,
ayant son siège social à L-1420 Luxembourg, 7, Avenue Gaston Diderich,
2. L'adresse du siège social de la société est établi à L-1420 Luxembourg, 7, Avenue Gaston Diderich.
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l'anglais, déclare que les comparantes l'ont requis de documenter le
présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et, en cas de divergence entre le texte anglais et le texte
français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé le présent acte avec le
notaire.
141262
L
U X E M B O U R G
Signé: Rachel HAFEDH, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 18 août 2014. Relation GRE/2014/3339. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2014134662/311.
(140153226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2014.
XXL All Sports United S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 179.794.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 août 2014.
Référence de publication: 2014132859/10.
(140150351) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2014.
Cam Luxembourg G.m.b.h., Société à responsabilité limitée unipersonnelle,
(anc. C&J Luxembourg G.m.b.H.).
Siège social: L-7374 Bofferdange, 241, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 136.202.
Im Jahre zwei tausendvierzehn, den achtundzwanzigsten Juli.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster (Grossherzogtum Luxemburg).
SIND ERSCHIENEN:
1. Herr Marc Oliver JANSEN, Kaufmann, geboren am 19. Juni 1986 in Hong Kong (China), wohnhaft in L-7374 Bof-
ferdange, 241, route de Luxembourg.
2. Herr Hannspeter JANSEN, Kaufmann, geboren am 8. Oktober 1944 in Bad Kissingen (Deutschland), wohnhaft in
L-7374 Bofferdange, 241, route de Luxembourg.
Welche Komparenten, handelnd wie eingangs erwähnt, den amtierenden Notar ersuchen folgendes zu beurkunden:
- Dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung „C&J LUXEMBOURG G.m.b.H“, mit Sitz in L-7374 Bofferdange, 241,
route de Luxembourg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer
136.202, gegründet wurde gemäß Urkunde aufgenommen durch Maître Aloyse BIEL, damals Notar mit dem Amtssitz in
Esch-sur-Alzette, am 7. Januar 2008, veröffentlicht im Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 626
vom 13. März 2008.
- Dass das Gesellschaftskapital zwölftausendfünfhundert Euro und (EUR 12.500,-) beträgt, eingeteilt in hundert (100)
Anteile mit einem Nominalwert von je hundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125)
- Dass Herr Marc Oliver JANSEN, vorbenannt, handelnd in seiner Eigenschaft als alleiniger Gesellschafter der vorge-
nannten Gesellschaft „C&J LUXEMBOURG G.m.b.H“, den amtierenden Notar ersucht, die von ihm in außerordentlicher
Generalversammlung gefassten Beschlüsse zu dokumentieren wie folgt:
<i>Erster Beschlussi>
Herr Marc Oliver JANSEN, vorbenannt, erklärt hiermit seine hundert (100) Anteile an Herrn Hannspeter JANSEN,
vorbenannt, abzutreten und zu übertragen unter der gesetzlichen Gewähr rechtens, zum Preise von zweitausend Euro
(EUR 2.000,-).
Der vorerwähnte Abtretungspreis wurde bereits vor Aufnahme gegenwärtiger Urkunde von den Ankäufern bezahlt,
was der Verkäufer ausdrücklich anerkennt, und worüber er Quittung und Titel bewilligt.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt die Bezeichnung der Gesellschaft in „CAM Luxembourg G.m.b.H.“ zu ändern und
Artikel 3 folgenden Wortlaut zu geben:
„ Art. 3. Der Name der Gesellschaft mit beschränkter Haftung lautet „CAM Luxembourg G.m.b.H.“.
<i>“Kosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr
achthundertfünfzig Euro (EUR 850,-) abgeschätzt.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
141263
L
U X E M B O U R G
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem amtierenden Notar nach Namen,
gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtiges Urkunde mit dem Notar un-
terschrieben.
Gezeichnet: Oliver JANSEN, Hannspeter JANSEN, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 04 août 2014. Relation GRE/2014/3079. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2014132342/45.
(140150202) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2014.
Aardvark Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 8.935.
Les comptes annuels au 30 septembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014132921/10.
(140151160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2014.
Casa-Lux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9990 Weiswampach, 15, Duarrefstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 100.551.
<i>Auszug aus dem Protokoll der außerordentlichen Generalversammlung vom 26. Mai 2014i>
Die Versammlung beschließt einstimmig die Abberufung der Aktiengesellschaft „ALUTHERMO“, mit Sitz in B-4790
Burg-Reuland Nr.93 B, mit Herrn Lambert JAKOBS als ständigem Vertreter, von ihrem Mandat als Verwaltungsratsmit-
glied.
Die Versammlung ernennt einstimmig zum neuen Verwaltungsratsmitglied die Gesellschaft „CHAPALIS A.G.“, mit Sitz
in L-9990 Weiswampach, Duarrefstrooss Nr. 15, mit Herrn Lambert JAKOBS, wohnhaft in B-4780 St.Vith, Steinkelt
Galhausen 23, als ständigem Vertreter. Das Mandat endet unmittelbar nach der ordentlichen Generalversammlung, welche
im Jahre 2019 abgehalten wird.
Die Generalversammlung nimmt zur Kenntnis, dass der Verwaltungsrat sich aus drei Mitgliedern zusammensetzt:
- Lambert JAKOBS, B-4780 St.Vith, Steinkelt Galhausen 23
- Nandy MEZZATESTA, B-4780 St.Vith, Steinkelt Galhausen 23
- CHAPALIS A.G., L-9990 Weiswampach, Duarrefstrooss Nr.15
CHAPALIS A.G. bezeichnet Herrn Lambert JAKOBS, wohnhaft in B-4780 St.Vith, Steinkelt Galhausen 23, als ihren
ständigen Vertreter im Verwaltungsrat der Aktiengesellschaft „CASA-LUX“
Einstimmig wird Herr Lambert JAKOBS als delegierter Verwalter abberufen und die Aktiengesellschaft „CHAPALIS
A.G.“ mit Sitz in L-9990 Weiswampach, Duarrefstrooss Nr.15, mit Herrn Lambert JAKOBS, wohnhaft in B-4780 St.Vith,
Steinkelt Galhausen 23, als ständigem Vertreter, als delegierter Verwalter ernannt. Das Mandat endet unmittelbar nach
der ordentlichen Generalversammlung, welche im Jahre 2019 abgehalten wird.
Référence de publication: 2014133011/25.
(140151340) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2014.
Bleu Book Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2518 Luxembourg, 54, rue Schetzel.
R.C.S. Luxembourg B 171.986.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014132978/9.
(140151237) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2014.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
141264
Aardvark Investments S.A.
Aardvark Investments S.A.
Active Solutions S.à r.l.
AKT Investments S.à r.l.
Altra Partners S.A.
APEX Technologies S.à r.l.
Arianne Properties S.à r.l.
Artek SA
ATEEL - Allied Technology Experts Enterprise of Luxembourg S.à r.l.
Auberge de l'Our
Balspeed Re S.A.
Bautrafix S.à.r.l.
B.C.I. Sàrl
Bestebreurtje S.A.
Biname Investments S.A.
Bleu Book Group S.A.
Borletti Group High Retail S.C.A.
Borletti Group High S.C.A.
Cambenes S.A.
Cam Luxembourg G.m.b.h.
Casa-Lux S.A.
Chaud-Froid S.à r.l.
C&J Luxembourg G.m.b.H.
Compagnie Investissement Europe Holding Luxembourg S.A.
Cor International S.à r.l. Soparfi
Crown Premium Private Equity VI Master S.C.S,SICAV-FIS
Dal Futura S.à r.l.
DGAD International S.àr.l.
Dolce Vita S.à r.l.
Domus International S.A.
Doppler Tim GmbH
ECH S.A.
Filomena S.A.
Forticrus
Gavento S.A., SPF
Halltex Luxemburg G.m.b.H.
HW Invest S.A.
International Shipowners Reinsurance Company S.A.
KDC Investments,Luxembourg Branch
Lehnkering Shipping Lux S.A.
Lovi
Minett Private S.A.
Minett Private S.A. SPF
MOLLING Patrick Agence, S. à r.l.
NCR International & Co Luxembourg Holdings SNC
New Hope Investments S.à r.l.
Northam CCPF II PropCo BTS (J) S.à r.l.
Norwin Group S.A.
Oceana Hold Co. II S.à r.l.
Oceana Hold Co. I S.à r.l.
Oktav RE
Omnifone S.à r.l.
Private VCL S.A.
ProLogis France XXXV S.àr.l.
Redcor Reaseguros S.A.
Sodium Investment S.à r.l.
Temrex S.à r.l.
Tevaco S.à r.l.
The Taplow Group S.A.
Twist Beauty International Holdings S.A.
Utilis International S.à r.l.
Westbridge S.à r.l.
XXL All Sports United S.à r.l.