logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2906

13 octobre 2014

SOMMAIRE

Alma Jem S.C.I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139447

AL.VE S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139448

Arissa Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139448

Cafe 16 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139442

Corton Meyney S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139442

Degroof PE Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139488

E.I.M.A. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139487

Gerlach Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

139454

Herblay S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139488

Heureko S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139442

Hicof S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139442

International Strategy Corporation S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139446

Intuitip S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139443

IT-LUX software solutions S.A. . . . . . . . . . .

139443

Kapa Participations S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

139442

Key Concept Constructions S.à r.l.  . . . . . .

139447

Kiwi International Corporation S. à r.l. . . .

139449

Knewledge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139448

Kolibri s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139445

La Considération de l'Ange Blanc . . . . . . . .

139443

Larry II LM S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139447

Larry II Midco S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139450

Larry Topco S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139450

LEAF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139449

League Jinn S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139449

Le Mètre Carré S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139452

Liam Finance S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139443

Life Bond Lux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139477

LMLux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139443

Lululemon LU Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . .

139452

Luna S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139452

LuxCo 113 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139445

LuxCovering  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139445

Luxury Design S.C.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139457

Mangoo S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139449

Marco Zenner S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139452

Microfinance Enhancement Facility SA, SI-

CAV-SIF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139485

Natex S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139444

Navistar International Luxembourg Sàrl

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139450

Navistar Luxembourg Holding S.à r.l.  . . . .

139451

Nexus Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

139467

Nickel Grafton S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139453

Norbert KELLER A.G.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139446

Northam CCPF PropCo BTS (7) S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139445

Northam CCPF PropCo BTS (9) S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139446

Nubia Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139451

OCM Luxembourg Coppice Midco S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139444

Oracle Bucéphale S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

139452

Rancho Properties Holdings S.à r.l.  . . . . . .

139450

Restaurants Food Management I S.A.  . . . .

139447

Ribel Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139453

Saint George UCITS SICAV  . . . . . . . . . . . .

139444

Samson  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139448

SLCO SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

139453

Southern Participations S.A.  . . . . . . . . . . . .

139451

Spheretech International S.A.  . . . . . . . . . . .

139453

139441

L

U X E M B O U R G

Heureko S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 165.332.

Le Bilan au 31.12.2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014130679/10.
(140148447) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2014.

Hicof S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 205, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 166.515.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Isabelle Pairon.

Référence de publication: 2014130680/10.
(140148501) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2014.

Cafe 16 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R.C.S. Luxembourg B 127.699.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 août 2014.

SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2014132346/11.
(140150631) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2014.

Corton Meyney S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 67.894.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2014132356/11.
(140150258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2014.

Kapa Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1309 Luxembourg, 8, rue Charles IV.

R.C.S. Luxembourg B 36.959.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 août 2014.

<i>Pour KAPA PARTICIPATIONS S.A.
Mr CASTEL Patrick

Référence de publication: 2014130741/12.
(140147840) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2014.

139442

L

U X E M B O U R G

Intuitip S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4963 Clemency, 9, rue Basse.

R.C.S. Luxembourg B 148.042.

Le bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Clémency, le 18/08/2014.

Référence de publication: 2014130703/10.
(140148253) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2014.

IT-LUX software solutions S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6637 Wasserbillig, 41, Esplanade de la Moselle.

R.C.S. Luxembourg B 98.935.

Der Jahresabschluss am 31. Dezember 2010 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 18. August 2014.

Référence de publication: 2014130709/10.
(140148333) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2014.

LMLux, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9647 Doncols, 14, Chemin des Douaniers.

R.C.S. Luxembourg B 138.543.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés, dans leur version abrégée, au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg conformément à l’art. 79(1) de la loi du 19/12/2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014133221/11.
(140151252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2014.

La Considération de l'Ange Blanc, Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 176.658.

La Convention de Domiciliation, conclue en date du 28.03.2013 avec la société LA CONSIDERATION DE L'ANGE

BLANC SA, ayant précédemment son siège social à L-2420 Luxembourg, 11 Avenue Emile Reuter et inscrite au Registre
du Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B numéro 176.658, a été résiliée avec effet au 04/10/2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SOCIETE GENERALE BANK &amp; TRUST

Référence de publication: 2014133212/11.
(140151020) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2014.

Liam Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 124.814.

Le dépôt rectificatif des comptes annuels au 31 décembre 2013 déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg le 21 juillet 2014, sous la référence L140126541 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 août 2014.

Référence de publication: 2014130755/12.
(140148372) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2014.

139443

L

U X E M B O U R G

OCM Luxembourg Coppice Midco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 175.318.

Statuts coordonnés, suite à l’assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Blanche MOUTRIER, notaire de

résidence à Esch/Alzette agissant en remplacement de Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette en
date du 9 mai 2014 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 10 juin 2014.

Référence de publication: 2014130823/12.
(140148323) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2014.

Saint George UCITS SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 138.964.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée Générale Annuelle du 14 août 2014:

Est nommé nouveau liquidateur
Deloitte Tax &amp; Consulting, société à responsabilité limitée, 560A rue de Neudorf L-2220 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Saint George UCITS SICAV (en liquidation volontaire)
UBS Fund Services (Luxembourg) SA

Référence de publication: 2014132081/13.
(140149566) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2014.

Natex S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1128 Luxembourg, 28-30, Val Saint André.

R.C.S. Luxembourg B 77.582.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue au siège social en date du 14 août 2014

<i>Première résolution:

Les actionnaires approuvent les comptes de liquidation, le rapport de liquidation et les comptes du commissaire.

<i>Deuxième résolution:

Les actionnaires donnent décharge au commissaire aux comptes et au liquidateur.

<i>Troisième résolution:

L'endroit où seront archivés les livres et documents sociaux de la société pour une durée de 5 ans est fixé auprès de

la Fiduciaire Latitudes s.à r. l. ayant son siège à L-1128 Luxembourg, 30, Val St. André.

<i>Quatrième résolution:

Le boni de liquidation sera réparti entre les différents actionnaires.

<i>Cinquième résolution:

Les actionnaires décident de clôturer la liquidation décidée par acte notarié le 7 août 2014 auprès du notaire Weber

Alex, de résidence à Bascharage.

<i>Sixième résolution:

Les sommes n'ayant pu être remises au créanciers ou aux actionnaires seront déposées à la caisse des dépôts et

consignations.

Luxembourg, le 14 août 2014.

Pour copie conforme
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2014130817/27.
(140148429) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2014.

139444

L

U X E M B O U R G

Kolibri s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5411 Canach, 18, rue d'Oetrange.

R.C.S. Luxembourg B 168.683.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 18 août 2014.

Référence de publication: 2014130747/10.
(140148344) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2014.

Northam CCPF PropCo BTS (7) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: CAD 25.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 169.471.

Les comptes annuels pour la période du 08 juin 2012 (date de constitution) au 31 décembre 2012 ont été déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 août 2014.

Référence de publication: 2014130813/11.
(140147909) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2014.

LuxCovering, Société Coopérative.

Siège social: L-9779 Eselborn, 20, Op der Sang.

R.C.S. Luxembourg B 183.053.

EXTRAIT

Il est décidé par l'assemblée générale extraordinaire du 21 juillet 2014, du transfert du siège social à l'adresse suivante:

20, Op der Sang L9779 ESELBORN.

L'article 2 des statuts sera en conséquence libellé comme suit:
«Le siège social est établi à L-9779 ESELBORN, 20 Op der Sang. Il peut être transféré partout au Luxembourg par

simple décision de l'administration. La société peut également, par simple décision de l'administration, établir des sièges
administratifs, succursales, agences ou sièges d'exploitation au Grand duché de Luxembourg et à l'étranger»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014130763/15.
(140148433) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2014.

LuxCo 113 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 157.167,00.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 152.299.

En date du 14 août 2014, l'associé unique de la Société a pris la décision suivante:
- Transfert du siège social de la Société du 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg au 6, rue Jean Monnet, L-2180

Luxembourg, avec effet à compter du 6 Juin 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 août 2014.

<i>Pour la Société
TMF Luxembourg S.A.
<i>Agent domiciliataire
P.L.C. van Denzen / M.R.E.Watrin
<i>Director / Proxyholder

Référence de publication: 2014130762/18.
(140148486) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2014.

139445

L

U X E M B O U R G

International Strategy Corporation S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 100.769.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014130702/9.
(140148126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2014.

Northam CCPF PropCo BTS (9) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: CAD 25.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 169.500.

Les comptes annuels pour la période du 08 juin 2012 (date de constitution) au 31 décembre 2012 ont été déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 août 2014.

Référence de publication: 2014130815/11.
(140147910) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2014.

Norbert KELLER A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-9911 Troisvierges, 38-40, rue de Wilwerdange.

R.C.S. Luxembourg B 93.108.

<i>Auszug aus dem Protokoll der außergewöhnlichen Generalversammlung vom 1. August 2014

Es wurde u.a. beschlossen:

<i>Erster Beschluss:

Herr Norbert KELLER tritt als Präsident des Verwaltungsrates zurück. Herr KELLER bleibt weiterhin Mitglied des

Verwaltungsrates.

Herr Bruno AACHEN tritt als Mitglied des Verwaltungsrates zurück.
Herr Claude NIEDERKORN, geboren am 12. Januar 1944 in Arlon (B), wohnhaft in L-5969 Itzig, 44, rue de la Libération,

wird als neues Mitglied des Verwaltungsrates gewählt.

Herr Serge NIEDERKORN, geboren am 1. Juli 1969 in Luxemburg, wohnhaft in CH-8810 Horgen, Eggweg 15, wird

als neues Mitglied des Verwaltungsrates gewählt.

Herr  Pierre  FELTGEN,  geboren  am  27.  Oktober  1966  in  Luxemburg,  wohnhaft  in  L-1160  Luxemburg,  12-15  Bd

d'Avranches, wird als neues Mitglied des Verwaltungsrates gewählt.

Die Mandate der neuen Verwaltungsratsmitglieder enden zum Datum der Ordentlichen Generalversammlung des

Jahres 2019.

<i>Zweiter Beschluss:

Wird zum neuen Präsidenten des Verwaltungsrates Herr Claude NIEDERKORN, geboren am 12. Januar 1944 in Arlon

(B), wohnhaft in L-5969 Itzig, 44, rue de la Libération, gewählt.

<i>Dritter Beschluss:

Die Versammlung beschließt Herrn Serge NIEDERKORN, geboren am 1. Juli 1969 in Luxemburg, wohnhaft in CH-8810

Horgen, Eggweg 15, als neuen Delegierten des Verwaltungsrates zu bestimmen.

<i>Vierter Beschluss:

Die Versammlung bestätigt das Mandat des aktuellen Wirtschaftsprüfers.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, den 14. August 2014.

<i>Für Norbert KELLER A.G., Aktiengesellschaft
FIDUNORD S.à r.l.

Référence de publication: 2014130811/33.
(140148207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2014.

139446

L

U X E M B O U R G

Key Concept Constructions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2225 Luxembourg, 23, rue General Major Lunsford Oliver.

R.C.S. Luxembourg B 159.004.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014130731/9.
(140148008) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2014.

Larry II LM S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 164.776.

Les comptes annuels de la société Larry II LM S.à r.l. au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014130752/10.
(140147906) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2014.

Alma Jem S.C.I, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-9221 Diekirch, 138, rue Clairefontaine.

R.C.S. Luxembourg E 144.

L'an deux mille treize, le vingt-quatre décembre.
La soussignée:
Madame Marie KAUFMANN, femme au foyer, veuve de Monsieur Jean-Marie Erpelding, demeurant à L-9221 Diekirch,

138, rue Clairefontaine,

agissant en sa qualité d'associée unique de la société civile immobilière «ALMA JEM SCI DIEKIRCH», une société civile

immobilière avec siège social à L-9221 Diekirch, 138, rue Clairefontaine, immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous la section E numéro 144, décide suite au décès de Monsieur Jean-Marie ERPELDING du
24 février 2013, de révoquer Monsieur Jean-Marie ERPELDING en tant qu'administrateur-gérant de la société.

Fait et passé à Diekirch, date qu'en tête des présentes.
Référence de publication: 2014132266/16.
(140149969) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2014.

Restaurants Food Management I S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4963 Clemency, 9bis, rue Basse.

R.C.S. Luxembourg B 162.983.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 18 août 2014

Après délibération, l'Assemblée Générale prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
De transférer le siège social de la Société du 9, rue Basse, L-4963 Clémency au 9bis, rue Basse, L-4963 Clémency.
L'Assemblée accepte la démission de la société BDO De Chazal du Mée de son mandat de Commissaire aux comptes.
En remplacement du Commissaire aux comptes démissionnaire, l'assemblée a nommé la société ACCOUNTIS S.A.,

ayant son siège social à L - 2352 Luxembourg, rue Jean-Pierre Probst, 4, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le n° B146381.

Le mandat du Commissaire aux comptes nouvellement nommé prendra fin à l'issue de l' Assemblée Générale Annuelle

qui se tiendra en l'année 2017.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme.

Clémency, le 18 août 2014.

Référence de publication: 2014130869/19.
(140148362) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2014.

139447

L

U X E M B O U R G

Knewledge, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof, 4, rue d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 145.525.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014130744/9.
(140148476) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2014.

Samson, Société Civile.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg E 4.761.

La Société a pris acte du changement d'adresse de Karen Le Duc, associé de la Société, qui est désormais le 79, avenue

Georges Clémenceau, F-78110 Le Vésinet, France.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Samson

Référence de publication: 2014130879/11.
(140148089) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2014.

AL.VE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 117.056.

Il résulte des actes de la Société que Monsieur Riccardo Incani a présenté sa démission de ses fonctions d'administrateur

en date du 21 juillet 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

AL.VE S.A.
Société Anonyme
Signatures

Référence de publication: 2014132261/13.
(140150653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2014.

Arissa Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 148.545.

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire de la Société tenue en date du 21 août 2014 que
- Les démissions de M. Olivier LIEGEOIS et M. Luc GERONDAL, administrateurs de la Société ont été acceptées avec

effet au 21 août 2014;

- Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs de la Société, avec effet au 21 août 2014 et ce jusqu'à

l'assemblée générale qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2018:

* (i) Mme Sandrine BISARO, née le 28 juin 1969 à Metz, France, résidant professionnellement au 16, avenue Pasteur

L-2310 Luxembourg;

* (ii) Mme Christelle MATHIEU, née le 1 

er

 mars 1978 à Virton, Belgique, résidant professionnellement au 16, avenue

Pasteur L-2310 Luxembourg;

- Le mandat de Monsieur Patrick MOINET, administrateur et Président du Conseil d'administration de la Société a été

renouvelé et ce jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2018.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 août 2014.

Référence de publication: 2014132278/21.
(140150325) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2014.

139448

L

U X E M B O U R G

Kiwi International Corporation S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 108.098.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

KIWI INTERNATIONAL CORPORATION Sàrl

Référence de publication: 2014130742/10.
(140148031) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2014.

League Jinn S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 4-6, rue du Fort Rheinsheim.

R.C.S. Luxembourg B 147.263.

Le bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 juillet 2014.

Julien Ruggieri
<i>Gérant Unique

Référence de publication: 2014130767/12.
(140148301) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2014.

LEAF, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 37.669.

Les comptes annuels au 28 février 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 août 2014.

<i>Pour LEAF
Banque Degroof Luxembourg S.A.
<i>Agent Domiciliataire

Référence de publication: 2014130765/13.
(140148264) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2014.

Mangoo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1839 Luxembourg, 12-18, rue Joseph Junck.

R.C.S. Luxembourg B 171.380.

<i>Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 15 août 2014

Les associés adoptent à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

La nomination de Mademoiselle Nan WANG, demeurant à L-3730 Rumelange, 21, Grand-rue, comme nouvelle gérante

administrative pour une durée indéterminée.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale accorde également à la gérante administrative, Mademoiselle Nan WANG, le pouvoir de signa-

ture individuelle pour valablement engager la Société en toutes circonstances.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15/08/2014.

<i>Pour la Société
Mangoo S.à r.l.

Référence de publication: 2014130788/19.
(140147842) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2014.

139449

L

U X E M B O U R G

Larry II Midco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 162.682.

Les comptes annuels de la société Larry II Midco S.à r.l. au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et

des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014130753/10.
(140147862) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2014.

Larry Topco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 159.235.

Les comptes annuels de la société Larry TopCo S.à r.l. au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et

des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014130754/10.
(140148158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2014.

Navistar International Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 152.202.

Les  comptes  annuels  modifiés  au  31  octobre  2013  ont  été  déposés  au  registre  de  commerce  et  des  sociétés  de

Luxembourg, et remplacent les comptes au 31 octobre 2013 précédemment déposés au Registre de Commerce et des
Sociétés en date du 21 mai 2014 sous la référence L140084192.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 août 2014.

Luxembourg Corporation Company S.A.
Signatures
<i>Mandataire

Référence de publication: 2014130804/15.
(140147972) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2014.

Rancho Properties Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 188.582.

EXTRAIT

En date du 14 août 2014, l'associé unique a pris les résolutions suivantes:
- La démission de Travis Management S.A. en tant que gérant de la société est acceptée avec effet immédiat.
- Christian Fiil Lindekilde, ayant son adresse au 107 Ländischstrasse, 8706 Meilen, Suisse, est nommé en tant que gérant

A de la société avec effet immédiat et ce, pour une durée indéterminée.

- Charlotte Lahaije-Hultman, ayant son adresse au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est nommée en tant

que gérant B avec effet immédiat et ce, pour une durée indéterminée.

- Gulcin Tekes, ayant son adresse au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est nommée en tant que gérant

B avec effet immédiat et ce, pour une durée indéterminée.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 18 août 2014.

Référence de publication: 2014130854/19.
(140148261) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2014.

139450

L

U X E M B O U R G

Navistar Luxembourg Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 173.368.

Les  comptes  annuels  modifiés  au  31  octobre  2013  ont  été  déposés  au  registre  de  commerce  et  des  sociétés  de

Luxembourg, et remplacent les comptes au 31 octobre 2013 précédemment déposés au Registre de Commerce et des
Sociétés en date du 21 mai 2014 sous la référence L140084188.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 août 2014.

Luxembourg Corporation Company S.A.
Signatures
<i>Mandataire

Référence de publication: 2014130805/15.
(140147981) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2014.

Nubia Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 176.390.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions écrites prises par l'actionnaire unique de la Société en date du 13 août 2014 que:
- M. Luc GERONDAL et M. Olivier LIEGEOIS ont été révoqués de leur poste d'administrateurs de classe B de la

Société;

- Ont été nommés en tant qu'administrateurs de classe B, avec effet au 13 août 2014 et pour une période de six années:
* M. Livio GAMBARDELLA, né le 2 décembre 1975 à Terlizzi (Italie) et demeurant professionnellement au 16, avenue

Pasteur, L-2310 Luxembourg;

* Mme Yuliya BAY-LANGER, né le 20 février 1984 à Kyiv (Ukraine), demeurant professionnellement au 16, avenue

Pasteur, L-2310 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 août 2014.

Référence de publication: 2014130819/18.
(140148167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2014.

Southern Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 35.096.

<i>Résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire tenue exceptionnellement le 7 juillet 2014

1. les mandats d'Administrateurs de Madame Stéphanie COLLEAUX, employée privée, née le 2 décembre 1977 à

Dinant (B), demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, de Monsieur Christian FRAN-
ÇOIS, employé privé, né le 1 

er

 avril 1975 à Rocourt (B), demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086

Luxembourg, de Monsieur Philippe STOCK, employé privé, né le 10 septembre 1960 à Gosselies (B), demeurant pro-
fessionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de
six (6) ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2020;

2. le mandat de Commissaire aux Comptes de la société Fin-Contrôle S.A., société anonyme, ayant son siège social

au 12, rue Guillaume Kroll, Bâtiment F, L-1889 Luxembourg est reconduit pour une période statutaire de six (6) ans
jusqu'à l'Assemblée de l'an 2020.

Luxembourg, le 7 juillet 2014.

Certifié sincère et conforme
SOUTHERN PARTICIPATIONS S.A.
Signature

Référence de publication: 2014130918/21.
(140148122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2014.

139451

L

U X E M B O U R G

Marco Zenner S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4385 Ehlerange, Zare Est.

R.C.S. Luxembourg B 101.797.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014130789/9.
(140147881) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2014.

Le Mètre Carré S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6793 Grevenmacher, 42, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 87.292.

Der Jahresabschluss vom 31.12.2013 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014130764/9.
(140147844) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2014.

Lululemon LU Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 47.501,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 170.553.

Les comptes annuels au 31 janvier 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 août 2014.

Référence de publication: 2014130757/10.
(140148409) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2014.

Luna S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8041 Bertrange, 169, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 187.661.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 août 2014.

Référence de publication: 2014130759/10.
(140148445) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2014.

Oracle Bucéphale S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 168.758.

<i>Extrait des résolutions écrites de l'Associé unique en date du 13 août 2014

En date du 13 août 2014, l'Associé unique de la société Oracle Bucéphale S.à r.l. a prit les résolutions suivantes:
1. L'Associé unique décide d'accepter la démission, avec effet immédiat de Monsieur Frank Breitling de son poste de

gérant.

2. L' Associé unique décide de nommer, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée Monsieur Guillaume

Destruel, né le 28 avril 1973 à Paris (France), demeurant professionnellement au 44, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lu-
xembourg en tant que gérant.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014131451/16.
(140149164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2014.

139452

L

U X E M B O U R G

SLCO SA, Société Anonyme.

Siège social: L-3510 Dudelange, 10, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 163.483.

Remplace le dépôt initial L140119400
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014130912/11.
(140148117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2014.

Spheretech International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8049 Strassen, 2, rue Marie Curie.

R.C.S. Luxembourg B 137.867.

<i>Dépôt rectificatif du dépôt effectué le 3 mai 2013 portant le numéro de dépôt L130069707

Les comptes annuels rectifiés au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014130898/11.
(140147933) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2014.

Nickel Grafton S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 22, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 187.379.

Par résolutions prises en date du 4 août 2014, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Nomination de Gérard Becquer, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au

mandat de gérant, avec effet au 5 août 2014 et pour une durée indéterminée;

2. Acceptation de la démission de Stéphanie Charles, avec adresse professionnelle au 22, Grand Rue, 3 

e

 étage, L-1660

Luxembourg de son mandat de gérant, avec effet au 4 août 2014;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 août 2014.

Référence de publication: 2014130810/15.
(140148465) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2014.

Ribel Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 166.488.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions écrites prises par l'actionnaire unique de la Société en date du 13 août 2014 que:
- M. Luc GERONDAL et M. Olivier LIEGEOIS ont été révoqués de leur poste d'administrateurs de classe B de la

Société;

- Ont été nommés en tant qu'administrateurs de classe B, avec effet au 13 août 2014 et pour une période de six années:
* M. Livio GAMBARDELLA, né le 2 décembre 1975 à Terlizzi (Italie) et demeurant professionnellement au 16, avenue

Pasteur, L-2310 Luxembourg;

* M. Philippe SALPETIER, né le 19 août 1970 à Libramont (Belgique), demeurant professionnellement au 16, avenue

Pasteur, L-2310 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 août 2014.

Référence de publication: 2014130860/18.
(140148165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2014.

139453

L

U X E M B O U R G

Gerlach Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 172.073.

In the year two thousand fourteen, on the eighth day of the month of July,
before us Maître Marc Loesch, notary, residing in Mondorf-les-Bains, Grand-Duchy of Luxembourg,

there appeared:

Rysy Investments S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated

and existing under the laws of Luxembourg, with registered office at 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg,
having a share capital of EUR 152,359 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under
number B 172.918 (the Sole Shareholder),

acting in its capacity of Sole Shareholder of Gerlach Investments S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company

(société à responsabilité limitée) existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 11-13, boulevard
de la Foire, L-1528 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number
B 172.073 (the Company), incorporated pursuant to a notarial deed on 8 October 2012, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations (the Memorial) number 2760 of 14 November 2012.

The articles of association of the Company (the Articles) were amended for the last time pursuant to a notarial deed

on 4 June 2014, not yet published in the Memorial.

The Sole Shareholder is represented at the meeting by Mr Frank Stolz-Page, with professional address in Mondorf-les-

Bains,

by virtue of proxy under private seal given on July 8, 2014, which, initialled “ne varietur” by the appearing person and

the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following:
I. That the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company.
II. That the agenda of the meeting is worded as follows:
1. Increase of the share capital of the Company by an amount of five thousand four hundred fourteen euros (EUR

5,414) in order to bring the share capital from its current amount of one hundred forty-six thousand nine hundred six
euro (EUR 146,906) to one hundred fifty-two thousand three hundred twenty euros (EUR 152,320) by the issue of five
thousand four hundred fourteen (5,414) new shares (the New Shares) of the Company, having a nominal value of one
euro (EUR 1) each;

2. Subscription and payment of the New Shares by way of a contribution in kind consisting of a receivable of seven

hundred ninety-nine thousand nine hundred ninety-six euros (EUR 799,996); allocation of an amount equal to the nominal
value of the New Shares to the share capital of the Company and allocation of the balance to the freely distributable
share premium account of the Company;

3. Subsequent amendment of article 5 paragraph 1 of the Articles in order to reflect the increase of the share capital

adopted under item 2;

4. Miscellaneous.
III. That the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of five thousand four hundred

fourteen euros (EUR 5,414) in order to bring the share capital from its current amount of one hundred forty-six thousand
nine hundred six euro (EUR 146,906), to one hundred fifty-two thousand three hundred twenty euros (EUR 152,320) by
the issue of five thousand four hundred fourteen (5,414) New Shares, having a nominal value of one euro (EUR 1) each

<i>Subscription-payment of the New Shares

The Sole Shareholder records the subscription and the full payment of the New Shares by way of a contribution in

kind as follows:

The Sole Shareholder, represented as stated here above, hereby declares that it subscribes to five thousand four

hundred fourteen (5,414) New Shares of the Company and fully pays up such new shares and a share premium of seven
ninety-four thousand five hundred eighty-two euros (EUR 794,582) by way of a contribution in kind consisting of a definite,
due and payable receivable of seven hundred ninety-nine thousand nine hundred ninety-six euros (EUR 799,996) (the
"Contribution in Kind").

The Sole Shareholder, represented as stated above, declares that it is the sole holder and owner of the Contribution

in Kind and that there exist no impediments to the transfer thereof to the Company. Proof of the Sole Shareholder's
ownership of the Contribution in Kind has been shown to the undersigned notary.

139454

L

U X E M B O U R G

The Sole Shareholder declares that the Contribution in Kind has been the subject of a report by the board of managers

of the Company dated 8 July 2014 the conclusion of which reads as follows:

"In view of above, the board of managers of the Company believes that the value of the Contribution in Kind amounts

to seven hundred ninety-nine thousand nine hundred ninety-six euros (EUR 799,996) and is at least equal to the value of
the New Shares to be issued by the Company in consideration thereof and the share premium to be paid in relation
thereto".

A copy of such report after having been signed "ne varietur" by the notary, shall remain annexed to this deed for the

purpose of registration.

The Sole Shareholder resolves to allocate from the value of the Contribution in Kind an amount equal to the nominal

value of the New Shares so issued to the share capital account of the Company and the remainder to the freely distri-
butable share premium account.

<i>Second resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend article 5, paragraph 1 of the

Articles so that it shall henceforth read as follows:

“ Art. 5. Issued Capital. The issued capital of the Company is set at one hundred fifty-two thousand three hundred

twenty euros (EUR 152,320) divided into one hundred fifty-two thousand three hundred twenty (152,320)shares with a
nominal value of one euro (EUR 1) each, all of which are fully paid up."

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately two thousand one hundred euro (EUR 2,100.-).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxyholder of

above appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same
appearing party, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Mondorf-les-Bains, at the office of the undersigned notary, on the year

and day first above written.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party

signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatorze, le huitième jour du mois de juillet,
par devant Nous, Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorfles-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,

a comparu:

Rysy Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée luxembourgeoise, incorporée et existante sous le droit

luxembourgeois, ayant son siège social au 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, ayant un capital social d'EUR
152.359 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 172.918 (l’Associé
Unique),

agissant dans sa capacité d'Associé Unique de Gerlach Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée luxem-

bourgeoise  existante  sous  le  droit  luxembourgeois,  ayant  son  siège  social  au  11-13,  boulevard  de  la  Foire,  L-1528
Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 172.073 (la
Société), constituée suivant un acte notarié, le 8 octobre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
(le Mémorial) numéro 2760 du 14 novembre 2012.

Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois par acte notarié le 4 juin 2014, en cours

de publication au Mémorial.

Lors de l’assemblée générale, l’Associé Unique est représenté par Monsieur Frank Stolz-Page, avec adresse profes-

sionnelle à Mondorf-les-Bains,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée en date du 8 juillet 2014, qui, paraphée ne varietur par le mandataire

de la comparante et le notaire soussigné, restera annexé au présent acte notarié pour être déposé au même moment
aux autorités de l’enregistrement.

L'Associé Unique a requis le notaire soussigné d’acter ce qui suit:
I. Que l’Associé Unique détient toutes les parts sociales du capital social de la Société.
II. Que l’ordre du jour de l’assemblée est libellé comme suit:
1. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de cinq mille quatre cent quatorze euros (EUR 5.414)

afin de porter le capital social de son montant actuel de cent quarante-six mille neuf cent six euros (EUR 146.906) à cent
cinquante-deux mille trois cent vingt euros (EUR 152.320), par l’émission de cinq mille quatre cent quatorze (5.414)
nouvelles parts sociales de la Société (les Nouvelles Parts Sociales), ayant une valeur nominale d’un euro (EUR 1) chacune;

139455

L

U X E M B O U R G

2. Souscription et paiement des Nouvelles Parts Sociales par un apport en nature correspondant à une créance de

sept cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-ving-seize euros (EUR 799.996); affectation d'un montant égal à la
valeur nominale des Nouvelles Parts Sociales au capital social de la Société et affectation du solde au compte de prime
d'emission librement distribuable de la Société;

3. Modification subséquente de l’article 5 paragraphe 1 des Statuts afin de refléter l’augmentation de capital social

adoptée aux points ci-dessus;

4. Divers.
III. Que l’Associé Unique a décidé de prendre les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d’un montant de cinq mille quatre cent quatorze

euros (EUR 5.414) afin de porter le capital social de son montant actuel de cent quarante-six mille neuf cent six euros
(EUR 146.906) à cent cinquante-deux mille trois cent vingt euros (EUR 152.320) par l’émission de cinq mille quatre cent
quatorze (5.414) Nouvelles Parts Sociales, ayant une valeur nominale d’un euro (EUR 1) chacune.

<i>Souscription - Paiement des Nouvelles Parts Sociales

L’Associé Unique accepte la souscription et le paiement intégral des Nouvelles Parts Sociales par un apport en nature

de la manière suivante:

L'Associé Unique, représenté comme mentionné ci-dessus, déclare, par la présente, souscrire à cinq mille quatre cent

quatorze (5.414) Nouvelles Parts Sociales de la Société et payer entièrement ces Nouvelles Parts Sociales, ainsi qu'une
prime d'émission de sept cent quatre-vingt-quatorze mille cinq cent quatre-vingt-deux euros (EUR 794.582) par un apport
en nature correspondant à une créance déterminée, échue et exigible de sept cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent
quatre-vingt-seize euros (EUR 799.996) (l’"Apport en Nature").

L'Associé Unique, représenté comme mentionné ci-dessus, déclare qu'il est titulaire unique et propriétaire unique de

l’Apport en Nature et qu'il n'existe aucune entrave pour son transfert à la Société. Preuve de la propriété de l’Associé
Unique de l’Apport en Nature a été donnée au notaire soussigné.

L'Associé Unique déclare que l’Apport en Nature a fait l’objet d'un rapport du conseil de gérance de la Société daté

du 8 juillet 2014 dont la conclusion est ainsi formulée:

"Compte tenu de ce qui précède, le conseil de gérance de la Société considère que la valeur de l’Apport en Nature

représente sept cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-seize euros (EUR 799.996) et est au moins égale
à la valeur des Nouvelles Parts Sociales émises à la Société en contrepartie et à la prime d'émission versée à cet égard."

Une copie de ce rapport après avoir été signé "ne varietur" par notaire, sera annexé à cet acte aux fins de l’enregis-

trement.

L’Associé  Unique  décide  d’affecter  de  la  valeur  de  l’Apport  en  Nature  un  montant  égal  à  la  valeur  nominale  des

Nouvelles Parts Sociales ainsi émises au compte du capital social de la Société, et le solde au compte de la prime d'émission
librement distribuable de la Société.

<i>Seconde résolution

En conséquence des résolutions précédentes, l’Associé Unique décide de modifier l’article 5 paragraphe 1 des Statuts,

de sorte qu’il aura désormais la teneur suivante:

« Art. 5. Capital émis. Le capital social souscrit de la Société est fixé à cent cinquante-deux mille trois cent vingt euros

(EUR 152.320), représenté par cent cinquante-deux mille trois cent vingt (152.320) parts sociales d’une valeur nominale
d'un euro (EUR 1) chacune, souscrites et entièrement payées.»

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en

conséquence du présent acte sont estimés approximativement à deux mille cent euros (EUR 2.100,-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare que le mandataire de la partie comparante ci-dessus l’a

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, à la requête du même mandataire,
et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, le mandataire de la partie

comparante signant avec Nous, notaire, l’original du présent acte.

Signé: F. Stolz-Page, M. Loesch.
Enregistré à Remich, le 11 juillet 2014. REM/2014/1510. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

Pour expédition conforme,

139456

L

U X E M B O U R G

Mondorf-les-Bains, le 20 août 2014.

Référence de publication: 2014131855/166.
(140149865) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2014.

Luxury Design S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 189.575.

STATUTES

In the year two thousand and fourteen, on the fourth day of August.
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

1. Luxury Design Management S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée),

having its registered office at 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, in the process
of being registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies (Luxury Design Management),

hereby represented by Maître Tulay Sonmez, attorney-at-law, with professional address in Luxembourg, Grand Duchy

of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal; and

2. Luxury Design Holdings S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée),

having its registered office at 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with
the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 172.954 (Luxury Design),

hereby represented by Maître Tulay Sonmez, attorney-at-law, with professional address in Luxembourg, Grand Duchy

of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.

Such powers of attorney, after having been signed ne varietur by the representative of the appearing parties and the

undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

The appearing parties, represented as described above, have requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of incorporation of a corporate partnership limited by shares (société en commandite par actions), which is hereby
incorporated:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. There is hereby established among the subscribers and all these who may become owners of the shares

mentioned hereafter a société en commandite par actions under the name of “Luxury Design S.C.A.” (hereinafter the
Company),  which  will  be  governed  by  the  laws  of  Luxembourg,  in  particular  by  the  law  dated  10  August,  1915,  on
commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by the present articles of association (hereafter the
Articles).

Art. 2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
2.2 Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by

a decision of the Manager (as defined in article 9). Within the same borough, the registered office may be transferred
through simple resolution of the Manager. In the event that the Manager determines that extraordinary political, econo-
mical, and/or military events have occurred or are imminent which would interfere with the normal activities of the
Company at its registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the regis-
tered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such
provisional measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding such temporary
transfer, shall remain a Luxembourg company.

Art. 3. Object.
3.1 The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever and the administration, management, control and development of such participations.
The Company may in particular acquire by way of subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock,
shares and/or other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and/or other debt instruments and
more  generally  any  securities  and/or  financial  instruments  issued  by  any  public  or  private  entity  whatsoever.  It  may
participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. It may further make
direct or indirect real estate investments and invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other
intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

3.2 The Company may borrow in any form whatsoever. It may issue notes, bonds and debentures and any kind of debt

and/or equity securities. The Company may lend funds including, without limitation, the proceeds of any borrowings and/
or issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated companies and/or any other companies and the Company
may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or over some of

139457

L

U X E M B O U R G

its assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or obligations and undertakings of any other company,
and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any other company or person, in each case to the extent those
activities are not considered as regulated activities of the financial sector.

3.3 The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose

of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.

3.4 The Company may generally carry out any operations and transactions, which directly or indirectly favour or relate

to its object.

Art. 4. Duration.
4.1 The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2 The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the shareholders of the Company adopted in the

manner required to amend the Articles.

4.3 The Company shall not be dissolved in case the Manager resigns, is liquidated, is declared bankrupt or is unable to

continue its business. In such circumstances, article 10.5 shall apply.

II. Share capital - shares

Art. 5. Share capital.
5.1 The issued capital of the Company is set at thirty-one thousand euro (EUR 31,000), represented by three hundred

nine thousand nine hundred and ninety-nine (309,999) ordinary shares (actions/parts de commanditaire) (the Ordinary
Shares) and one (1) management share (action/part de commandité) (the Management Share), in registered form, having
a par value of ten eurocent (EUR 0.10) each, all fully subscribed and paid up. The Ordinary Shares and the Management
Share shall be together referred to as the shares and individually as a share, whenever the reference to a specific category
or class of shares is not justified.

5.2 The Management Share shall be held by Luxury Design Management S.à r.l. (as detailed in article 9 hereafter), as

unlimited liability shareholder (actionnaire commandité) and as Manager of the Company.

5.3 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these Articles.

Art. 6. Shares and register of shares.
6.1 The shares of the Company are in registered form.
6.2 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection

by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Ownership of shares is established
by registration in said share register. Certificates of such registration shall be issued upon request and at the expense of
the relevant shareholder.

6.3 The Company will recognise only one (1) holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall

appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.

6.4 Any transfer of registered shares shall become effective towards the Company and third parties through the

recording of a declaration of transfer into the register of shares signed and dated either (i) by the transferor and the
transferee or their representatives, or (ii) by the Company upon notification of the transfer to, or upon the acceptance
of the transfer by, the Company.

III. Liability of holders of shares

Art. 7. Management Share and Ordinary Shares.
7.1 The holder of the Management Share (hereafter the Unlimited Shareholder) is jointly, indefinitely and severally

liable for all liabilities of the Company which cannot be met from the assets of the Company.

7.2 The holder(s) of Ordinary Shares (hereafter the Limited Shareholder(s)) shall refrain from acting on behalf of the

Company in any manner or capacity other than by exercising their rights as shareholder(s) in general meetings, and shall,
in that capacity, only be liable for payment to the Company of the full subscription price of each Ordinary Share for which
they subscribed and have been issued and any other outstanding commitments and other liabilities towards the Company
associated with their undertaking to make a capital commitment to the Company. In particular, the holder(s) of Ordinary
Shares shall not be liable for any debts, liabilities and obligations of the Company beyond the amounts of such payments.

Art. 8. Restrictions on the transfer of shares.
8.1 The Management Share held by the Manager is exclusively transferable to a successor or additional Manager with

unlimited liability for the Company's financial obligations.

8.2 The Ordinary Shares are freely transferable in accordance with the provisions of the Law.

139458

L

U X E M B O U R G

IV. Management and Supervision

Art. 9. Management. The Company shall be managed by Luxury Design Management S.à r.l., a Luxembourg private

limited liability company (société à responsabilité limitée), in the process of being registered with the Luxembourg Register
of Commerce and Companies (the Manager), in its capacity as Unlimited Shareholder of the Company.

Art. 10. Management Powers.
10.1 The Manager is invested with the broadest power to perform all acts of administration and disposition in com-

pliance with the Company's corporate objects. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to
the general meeting of shareholders or to the Supervisory Board (as defined in article 13.1) fall within the competence
of the Manager.

10.2 The Manager shall have the power, on behalf and in the name of the Company, to carry out any and all of the

purposes of the Company and to perform all acts and enter into and perform all contracts and other undertakings that
it may deem necessary, advisable or useful or incidental thereto. Except as otherwise expressly provided, the Manager
has, and shall have, full authority in its discretion to exercise, on behalf of and in the name of the Company, all rights and
powers necessary or convenient to carry out the purposes of the Company.

10.3 The Manager may, from time to time, appoint officers or agents of the Company considered necessary for the

operation and management of the Company. The officers and/or agents appointed, unless otherwise stipulated in the
Articles, shall have the powers and duties given to them by the Manager.

10.4 The Manager shall take appropriate action to protect the interests of the Company and its shareholders as a

whole.

10.5 In the event of legal incapacity, liquidation or other permanent situation preventing the Manager from acting as

Manager of the Company, the Company shall not be immediately dissolved and liquidated, provided the Supervisory Board
appoints an administrator, who does not need to be a shareholder, to effect urgent or mere administrative acts, until a
general meeting of shareholders is held, which such administrator shall convene within fifteen (15) days of his appointment.
At such general meeting, the shareholders shall appoint a successor manager, in accordance with the quorum and majority
requirement for amendment of these articles of association (it being understood that the former manager shall not
participate in such vote). Any such appointment of a successor manager shall not be subject to the approval of the Manager.

Art. 11. Binding Signatures.
11.1 The Company will be bound towards third parties by the sole signature of the Manager, acting through one or

more of its duly authorised signatories as designated by the Manager at its sole discretion, or such person(s) to which
such power has been delegated.

11.2 Any litigation involving the Company either as plaintiff or as defendant will be handled in the name of the Company

by the Manager.

Art. 12. Conflict of Interests.
12.1 The transactions made between the Company and the Manager having an interest conflicting with that of the

Company are mentioned in the resolution of the Manager.

12.2 Any such conflict of interest shall be reported to the next general meeting of shareholders prior to taking any

resolution on any other item.

12.3 The preceding rules shall not apply where the decision of the Manager relates to current operations entered into

under normal conditions.

12.4 No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or

invalidated by the fact that the Manager or any one or more of the directors or officers of the Manager is interested in,
or is a director, associate, officer or employee of, such company or firm. Any director or officer of the Manager who
serves as a director, officer or employee of a company or firm with which the Company shall contract or otherwise
engage in business shall not, solely by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from
considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Art. 13. Supervisory Board/Independent auditors (réviseurs d’entreprises agréés).
13.1 The Company shall be supervised either by a board of a minimum of three (3) supervisors (the Supervisory Board)

appointed by the general meeting of shareholders which fixes their remuneration as well as the term of their office, or
by one or several independent auditors (réviseurs d'entreprises agréés), who will then replace the Supervisory Board
and who shall be vested with the powers set forth by law.

13.2 The independent auditors (réviseurs d'entreprises agréés) are appointed by a resolution of the general meeting

of shareholders which determines their number, remuneration and the term of their office, which may not exceed six
(6) years. Independent auditors (réviseurs d'entreprises agréés) may be re-appointed.

139459

L

U X E M B O U R G

V. General Meetings

Art. 14. Powers and Convening Notice.
14.1 The general meeting of shareholders shall represent all the shareholders of the Company. Without prejudice of

the provisions of article 10 of these Articles and to any other powers reserved to the Manager by virtue of the Law and
the present Articles, it shall have the powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

14.2 General meetings of shareholders shall be convened by the Manager. General meetings of shareholders shall be

convened pursuant to a notice given by the Manager setting forth the agenda and sent by registered letter at least eight
(8) days prior to the meeting to each shareholder at the shareholder's address recorded in the share register.

Art. 15. Procedure.
15.1 The annual meeting of shareholders will be held in Luxembourg at the registered office of the Company or at any

other place in Luxembourg and on the third (3 

rd

 ) Friday of the month of June in each year at 10.00 am or at such time

as shall be specified in the convening notices. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final
judgment of the Manager, exceptional circumstances so require.

15.2 Other meetings of shareholders may be held at such places and times as may be specified in the respective notices

of meeting.

15.3 If all the shareholders are present or represented at the general meeting of the shareholders and if they state

that they have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

15.4 All shareholders are invited to attend and speak at all general meetings of shareholders. A shareholder may act

at any general meeting of shareholders by appointing another person, who need not be a shareholder, as his proxy, in
writing, by electronic message or by telefax or any other means of transmission approved by the Manager capable of
evidencing such proxy. Such proxy shall be deemed valid, provided that it is not revoked, for any reconvened shareholders'
meeting. The general meetings of the shareholders shall be presided by the Manager or by a person designated by the
Manager. The chairman of the general meeting of shareholders shall appoint a secretary. The general meeting of share-
holders may elect a scrutineer.

15.5 Except as otherwise required by the Law or as otherwise provided herein, resolutions at the meeting of share-

holders duly convened will be passed by an absolute majority of those present and voting.

Art. 16. Ordinary Meetings.
16.1 The business ordinarily to be considered at a shareholders' meeting shall be the discussion and approval of the

annual accounts as presented by the Manager, the consideration and approval of the allocation of the results of the year
proposed by the Manager (including without any limitation the distribution of dividends), the appointment, removal and
remuneration of members of the Supervisory Board and the discharge to be given to the Manager and to the members
of the Supervisory Board.

16.2 All other business at a general meeting shall only be considered upon a proposal of the Manager unless otherwise

provided by the Law or in these Articles.

Art. 17. Extraordinary General Meeting.
17.1 Any general meeting of shareholders convened in order to consider a matter that does not fall within the scope

of article 16 of these Articles (including any proposal to amend the Articles, or to resolve on issues for which the Law
refers to the conditions required for the amendment of the Articles) shall be convened as an extraordinary general
meeting. At any such meeting, the shareholders may only validly deliberate if the quorum required by the Law is satisfied.

17.2 Resolutions shall be passed by at least two thirds of the votes cast, provided that no resolution at any extraordinary

general meeting of shareholders shall be validly passed unless approved by the Manager, unless otherwise provided for
by these Articles.

Art. 18. Minutes. The minutes of the general meeting of shareholders shall be signed by the board of the meeting.

Copies or extracts of these minutes to be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the Manager.

VI. Accounting year - Allocation of Profits

Art. 20. Accounting Year. The accounting year of the Company shall begin on the first (1 

st

 ) of January and shall

terminate on the thirty-first (31 

st

 ) of December each year.

Art. 21. Accounts, appropriation of profits.
21.1 The Manager shall have the responsibility to establish the annual balance sheet and profit and loss account of the

Company in accordance with applicable provisions of law. Such account shall be submitted to the shareholders' meeting
for approval.

21.2 Out of the net profits of each year, an amount equal to five percent (5%) shall be allocated to the legal reserve

account. This allocation ceases to be compulsory when such reserve is equal to ten percent (10%) of the issued share
capital of the Company.

139460

L

U X E M B O U R G

21.3 Out of the balance there may be a distribution of dividends to the holders of shares upon a proposal of the

Manager approved by decision of a general meeting of shareholders in accordance with the provisions set forth in these
Articles, provided that such distribution cannot exceed the amount proposed by the Manager.

21.4 Interim dividends may be declared and paid by the Manager subject to observing the terms and conditions provided

for by the Law.

21.5 The share premium account may be distributed to shareholders upon proposal of the Manager approved by a

decision of a general meeting of shareholders. The general meeting of shareholders may, upon a proposal of the Manager,
decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal reserve account.

VII. Dissolution - Liquidation

Art. 22. Appointment of liquidators. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out

by one liquidator (if a legal entity) or one or more liquidators, (if natural persons) named by the general meeting of
shareholders effecting such dissolution upon proposal by the Manager. Such meeting shall determine their powers and
their remuneration

Art. 23. Distribution of liquidation proceeds. The net liquidation proceeds shall be paid to the holders of Ordinary

Shares and the holder of the Management Share in the proportion of their respective holdings on the basis that the
Ordinary Shares and the Management Share shall rank pari passu.

VIII. General provisions

Art. 24. Applicable law. All matters not governed by these Articles are to be determined in accordance with the Law.

<i>Transitory provision

1. The first financial year shall begin on the date of this deed and terminate on December 31, 2014.
2. The first annual general meeting of shareholders shall be held in 2015.
3. Interim dividends may also be distributed during the Company's first financial year.

<i>Subscription - Payment

1. Luxury Design Management, represented as stated above, declared to subscribe for one (1) Management Share in

registered form, with a par value of ten eurocent (EUR 0.10), and to fully pay it up by way of a contribution in cash
amounting to ten eurocent (EUR 0.10).

2. Luxury Design, represented as stated above, declared to subscribe for three hundred and nine thousand nine hundred

and ninety-nine (309,999) Ordinary Shares in registered form, with a par value of ten eurocent (EUR 0.10) each, and to
fully pay them up by way of a contribution in cash amounting to thirty thousand nine hundred and ninety-nine euro and
ninety eurocent (EUR 30,999.90).

The amount of thirty-one thousand euro (EUR 31,000) is at the disposal of the Company, as it has been proved to the

undersigned notary by way of a blocking certificate, who expressly acknowledges it.

<i>Statement

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Articles 26, 26-3 and 26-5 of the

Law of August 10, 1915 on Commercial Companies, as amended, have been fulfilled and expressly bears witness to their
fulfilment.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its incorporation are estimated at approximately EUR 1.500,-.

<i>Resolutions of the shareholders

Immediately after the incorporation of the Company, Luxury Design Management and Luxury Design, being the sha-

reholders of the Company, representing the entirety of the subscribed share capital have passed the following resolutions:

1. The following entity is appointed as independent auditor (réviseur d'entreprises agréé) of the Company for a re-

newable term of six (6) years starting from the date of the present deed until the date of the annual general meeting of
the shareholders of the Company resolving upon the approval of the annual accounts for the financial year ended on
December 31, 2019:

KPMG Luxembourg, having its registered office at 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, registered with the Luxem-

bourg Register of Commerce and Companies under number B 149.133.

2. The registered office of the Company is set at 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of

Luxembourg.

The undersigned notary made aware the appearing parties of the necessity to appoint a permanent representative of

the General Partner.

139461

L

U X E M B O U R G

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy-holder, she signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le quatre août.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

ONT COMPARU:

1. Luxury Design Management S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège

social au 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en cours d’immatriculation auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (Luxury Design Management),

ici représentée par Maître Tulay Sonmez, avocat à la Cour, avec adresse professionnelle à Luxembourg, Grand-Duché

de Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé; et

2. Luxury Design Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social

au 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 172.954 (Luxury Design),

ici représentée par Maître Tulay Sonmez, avocat à la Cour, avec adresse professionnelle à Luxembourg, Grand-Duché

de Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé.

Lesdites procurations, après signature "ne varietur" par le mandataire des parties comparantes et le notaire instru-

mentant, resteront annexées au présent acte pour les formalités de l’enregistrement.

Les parties comparantes, représentées comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte

constitutif d'une société en commandite par actions qui est ainsi constituée:

I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée

Art. 1 

er

 . Dénomination.  Il est constitué par le présent acte entre toutes les personnes qui sont actionnaires en ce

jour et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après mentionnées une société en commandite par actions
sous la dénomination de «Luxury Design S.C.A.» (ci-après la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en
particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la Loi), et par les présents
statuts (ci-après les Statuts).

Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
2.2. Sur décision du Gérant (tel que défini à l’article 9) des succursales, filiales ou autres bureaux peuvent être établis

tant au Grand-duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Le siège social peut être transféré à l’intérieur de la même munici-
palité par simple décision du Gérant. Lorsque le Gérant estime que des évènements extraordinaires d’ordre politique,
économique et/ou militaire qui seraient de nature à compromettre l’activité normale de la Société à son siège social, ou
la communication aisée entre le siège social et l’étranger, se sont produits ou sont imminents, le siège social peut être
transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances extraordinaires; ces mesures pro-
visoires n’auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, qui nonobstant le transfert provisoire de son siège
social, restera une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet.
3.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l’étranger, dans toutes sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit, et l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces parti-
cipations. La Société peut en particulier acquérir par souscription, achat, échange ou de toute autre manière tous titres,
actions et/ou autres titres de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et/ou autres instruments de dette,
et, en général tous titres et/ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la
création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra en outre effectuer
directement ou indirectement des investissements immobiliers et investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille
de brevets ou autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder à l’émission de billets à ordre,

obligations et emprunts obligataires et autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de participation. La Société peut
prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations ou titres
de participation, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toutes autres sociétés et la Société peut également consentir des
garanties et nantir, céder, grever de charges ou bien créer et accorder des sûretés portant sur la totalité ou sur une
partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et engagements et/ou les obligations et engagements de toute

139462

L

U X E M B O U R G

autre société ou personne et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toute autre société ou personne, dans
chaque cas, dans la mesure où ces activités ne constituent pas des activités réglementées du secteur financier.

3.3. La Société peut, de façon générale, employer toutes les techniques et instruments liés à ses investissements en

vue de leur gestion efficace, en ce compris les techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de
crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

3.4. La Société peut de façon générale effectuer toutes les opérations et transactions qui directement ou indirectement

favorisent ou se rapportent à son objet social.

Art. 4. Durée.
4.1. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
4.2. La Société peut à tout moment être dissoute par une résolution des actionnaires de la Société adoptée selon les

modalités requises pour la modification des Statuts.

4.3. La Société ne sera pas dissoute du fait de la démission du Gérant, de sa liquidation, de sa mise en faillite ou de son

incapacité à poursuivre ses affaires. Dans de telles circonstances, l’article 10.5 s’appliquera.

II. Capital Social - actions

Art. 5. Capital social.
5.1. Le capital émis de la Société est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000), représenté par trois cent neuf mille

neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (309.999) actions ordinaires de commanditaire (les Actions Ordinaires) et une (1) action
de commandité (l’Action de Commandité), sous la forme nominative, ayant une valeur nominale de dix cents (EUR 0,10)
chacune, toutes souscrites et entièrement libérées. Les Actions Ordinaires et l’Action de Commandité seront désignées
ensemble comme les actions et individuellement comme une action, chaque fois que la référence à une catégorie ou à
une classe particulière d’actions n’est pas justifiée.

5.2. L’Action de Commandité sera détenue par Luxury Design Management S.à r.l. (comme décrit à l’article 9 ci-après),

en qualité d’actionnaire commandité et en qualité de Gérant de la Société.

5.3. Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution de l’assemblée générale des ac-

tionnaires, adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

Art. 6. Actions et registre des actions.
6.1. Toutes les actions de la Société seront émises sous forme nominative.
6.2. Un registre des actions sera tenu au siège social de la Société où il pourra être examiné par tout actionnaire. Ce

registre contiendra les indications prévues par la Loi. La propriété des actions s'établit par une inscription sur ledit registre.
Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, à la demande et aux frais de l’actionnaire concerné.

6.3. La Société ne reconnaît qu'un (1) propriétaire par action. Si une action est détenue par plusieurs personnes, ces

personnes devront désigner un mandataire unique qui les représentera à l’égard de la Société. La Société aura le droit de
suspendre l’exercice de tous les droits attachés à l’action jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme
mandataire auprès d'elle.

6.4. Toute cession d'actions nominatives sera opposable à la Société et aux tiers par l’enregistrement d'une déclaration

de cession dans le registre des actions signée et datée soit (i) par le cédant et le cessionnaire ou leurs représentants, soit
(ii) par la Société sur notification de la cession à la Société, ou par l’acceptation de la cession par la Société.

III. Responsabilité des actionnaires

Art. 7. Actions de Commandité et Actions Ordinaires.
7.1. Le détenteur de l’Action de Commandité (ci-après l’Actionnaire Commandité) est conjointement, solidairement

et indéfiniment tenu des engagements de la Société qui ne peuvent être couverts par les actifs de la Société.

7.2. Il est défendu au(x) détenteur(s) d’Actions Ordinaires (ci-après les Actionnaires Commanditaires) d’agir pour le

compte de la Société, d’aucune manière et en aucune capacité que ce soient, autrement que par l’exercice de leurs droits
en tant qu’actionnaire(s) lors des assemblées générales, et seront, en cette capacité, uniquement responsables du paiement
à la Société de la totalité du prix de souscription de chaque Action Ordinaire qu’ils ont souscrite et qui ont été émises
et tous autres engagements en cours et autres responsabilités vis-à-vis de la Société en rapport avec leur engagement
d’effectuer un apport au capital de la Société. En particulier, le(s) détenteur(s) des Actions Ordinaires ne seront pas
responsables des dettes et obligations de la Société au-delà des montants de ces paiements.

Art. 8. Restrictions au transfert d’actions.
8.1.  L’Action  de  Commandité  détenue  par  le  Gérant  est  exclusivement  cessible  à  un  successeur  ou  à  un  Gérant

supplémentaire dont la responsabilité pour les obligations financières de la Société est illimitée.

8.2. Les Actions Ordinaires sont librement cessibles, conformément aux dispositions de la Loi.

139463

L

U X E M B O U R G

IV. Gérance et Surveillance

Art. 9. Gérance. La Société sera gérée par Luxury Design Management S.à r.l., une société à responsabilité limitée de

droit luxembourgeois, en cours d’immatriculation auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (le
Gérant), en sa qualité d’Actionnaire Commandité de la Société.

Art. 10. Pouvoirs de Gestion.
10.1. Le Gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes de gestion et de disposition en

conformité avec l’objet social de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la Loi ou les
présents Statuts à l’assemblée générale des actionnaires ou au Conseil de Surveillance (comme défini à l’article 13.1)
appartiennent au Gérant.

10.2. Le Gérant aura le pouvoir, pour le compte et au nom de la Société, de réaliser tous les objectifs de la Société et

d’effectuer tous les actes et de conclure et de délivrer tous les contrats et tous autres engagements qui lui semblent
nécessaires, opportuns, utiles ou accessoires à la réalisation de ces objectifs. Sauf disposition contraire expresse, le Gérant
a et aura pleine autorité à sa discrétion pour exercer pour le compte et au nom de la Société tous droits et pouvoirs
nécessaires ou utiles en vue de réaliser les objectifs de la Société.

10.3. Le Gérant peut, de temps à autre, s’il le juge nécessaire pour les opérations et la gestion de la Société, nommer

des fondés de pouvoir ou agents de la Société. Les fondés de pouvoir et/ou les agents désignés, sauf disposition contraire
dans les Statuts, auront les pouvoirs et obligations qui leur seront attribués par le Gérant.

10.4. Le Gérant prendra toute mesure appropriée en vue de préserver les intérêts de la Société et de ses actionnaires

en général.

10.5. En cas d’incapacité juridique, de liquidation ou autre situation permanente qui empêche le Gérant d’agir en qualité

de Gérant de la Société, la Société ne sera pas immédiatement dissoute et liquidée, à condition que le Conseil de Sur-
veillance  nomme  un  administrateur,  qui  n’est  pas  tenu  d’être  un  actionnaire,  pour  effectuer  des  actes  urgents  ou
simplement administratifs et ce jusqu’à ce qu’une assemblée générale des actionnaires soit tenue, une telle assemblée
devant être convoquée par cet administrateur dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa nomination. Lors de
cette assemblée générale, les actionnaires nommeront un nouveau gérant, dans le respect des conditions de quorum et
de majorité requises pour la modification des Statuts (étant entendu que le précédent gérant ne participe pas audit vote).
Une telle nomination d’un nouveau gérant ne sera pas sujette à l’accord du Gérant.

Art. 11. Pouvoir de signature.
11.1. La Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la seule signature du Gérant, agissant par le biais d’une ou de

plusieurs personnes dûment habilitées à signer et désignées par le Gérant à son unique appréciation, ou par la signature
de(s) personne(s) à qui ce pouvoir aura été délégué.

11.2. Tout contentieux dans laquelle la Société serait partie demanderesse ou défenderesse sera réglé au nom de la

Société par le Gérant.

Art. 12. Conflit d’intérêts.
12.1. Les transactions conclues entre la Société et le Gérant qui ont un intérêt autre que celui de la Société sont

mentionnés dans la résolution du Gérant.

12.2 Un tel conflit d'intérêt devra être déclaré à la prochaine assemblée générale des actionnaires avant tout vote sur

d'autres résolutions.

12.3 Les alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque la décision du Gérant concerne des opérations courantes

conclues dans des conditions normales.

12.4. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d'autre société ou entreprise ne sera affecté ou invalidé

par le fait que le Gérant ou un ou plusieurs administrateurs ou représentants du Gérant y auront un intérêt personnel,
ou sont un administrateur, associé, représentant ou employé de cette société ou entreprise. Tout administrateur ou
représentant du Gérant qui remplira en même temps des fonctions d'administrateur, représentant ou employé d'une
société ou entreprise avec laquelle la Société pourrait contracter ou entrerait autrement en relations d'affaires ne sera
pas, pour le seul motif de cette appartenance à cette société ou entreprise, automatiquement empêché de donner son
avis et de voter ou d'agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou opération.

Art. 13. Conseil de Surveillance/Réviseurs d’entreprises agréés.
13.1. La Société est surveillée soit par un conseil de surveillance composé de trois membres au moins (le Conseil de

Surveillance) désignés par l’assemblée générale des actionnaires qui fixe leur rémunération ainsi que la durée de leur
mandat, ou par un ou plusieurs réviseurs d’entreprises agréés, qui remplaceront alors le Conseil de Surveillance et qui
auront les pouvoirs qui leur sont donnés par la Loi.

13.2. Les réviseurs d’entreprises agréés sont nommés par une résolution de l’assemblée générale des actionnaires qui

détermine leur nombre, rémunération et la durée de leurs mandats, lequel ne peut dépasser six (6) ans. Les réviseurs
d’entreprises agréés sont rééligibles.

139464

L

U X E M B O U R G

V. Assemblées générales

Art. 14. Pouvoirs et Avis de Convocation.
14.1. L’assemblée générale des actionnaires représentera tous les actionnaires de la Société. Sans préjudice des dis-

positions de l’article 10 des présents Statuts et de tout autre pouvoir réservé au Gérant en vertu de la loi et des présents
Statuts, l’assemblée générale aura les pouvoirs d’ordonner, d’exécuter ou de ratifier les actes relatifs aux opérations de
la Société.

14.2. Les assemblées générales des actionnaires seront convoquées par le Gérant. Les assemblées générales des ac-

tionnaires sont convoquées suivant un avis du Gérant qui fixe l’ordre du jour et qui est envoyé à chaque actionnaire par
lettre recommandée huit (8) jours au moins avant l’assemblée, à l’adresse de l’actionnaire qui figure dans le registre des
actions.

Art. 15. Procédure.
15.1. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au Luxembourg, au siège social de la Société ou en tout

autre lieu au Luxembourg le troisième (3e) vendredi du mois de juin de chaque année à 10 heures ou à la date indiquée
dans les convocations. L’assemblée générale annuelle peut se tenir à l’étranger si le Gérant constate souverainement que
des circonstances exceptionnelles l’exigent.

15.2. D’autres assemblées des actionnaires pourront être tenues aux lieux et heures spécifiés dans les convocations

des assemblées respectives.

15.3. Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée générale des actionnaires et s’ils déclarent

avoir été informés de l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée pourra se tenir sans convocation préalable.

15.4.  Tous  les  actionnaires  sont  invités  à  participer  et  à  prendre  la  parole  à  toutes  les  assemblées  générales  des

actionnaires. Un actionnaire peut, et ce pour toute assemblée générale, nommer comme mandataire une autre personne
actionnaire ou non, par écrit, e-mail ou téléfax ou tout autre moyen de communication approuvé par le Gérant assurant
l’authenticité de la procuration. Cette procuration sera considérée comme valable, à condition qu’elle ne soit pas révo-
quée, pour toutes assemblées des actionnaires reconvoquées. Les assemblées générales des actionnaires seront présidées
par le Gérant ou par une personne désignée par le Gérant. Le président de l’assemblée générale des actionnaires nommera
un secrétaire. L’assemblée générale des actionnaires peut élire un scrutateur.

15.5. Les résolutions de l’assemblée générale des actionnaires dûment convoquée seront prises à la majorité absolue

des actionnaires présents et votants, sauf exigence contraire de la Loi ou des présents Statuts.

Art. 16. Assemblées Ordinaires.
16.1. Les affaires ordinaires de la Société devant être traitées lors des assemblées des actionnaires concerneront la

discussion et l’approbation des comptes annuels tels que présentés par le Gérant, la contrepartie et l’approbation de la
répartition des résultats annuels proposés par le Gérant (y compris, mais sans limitation, la distribution des dividendes),
la nomination, la révocation et la rémunération des membres du Conseil de Surveillance ainsi que la décharge à donner
au Gérant et aux membres du Conseil de Surveillance.

16.2. D’autres affaires pourront être évoquées lors d’une assemblée générale uniquement sur proposition du Gérant

sauf disposition contraire de la Loi ou des présents Statuts.

Art. 17. Assemblée Générale Extraordinaire.
17.1. Toute assemblée générale des actionnaires convoquée dans le but d’examiner un point qui n’entre pas dans le

champ d’application de l’Article 19 des présents Statuts (y compris toute proposition de modification des Statuts ou la
décision sur des points pour lesquels la loi fait référence aux conditions exigées pour la modification des Statuts) doit
être convoquée en tant qu’assemblée générale extraordinaire. Lors de cette assemblée, les actionnaires ne délibèrent
valablement que si le quorum requis par la loi est atteint.

17.2. Les décisions seront prises par au moins les deux tiers des votes exprimés, sous réserve d’avoir été approuvées

par le Gérant lors de toute assemblée générale extraordinaire des actionnaires, sauf disposition contraire des présents
Statuts.

Art. 18. Procès-verbaux. Les procès-verbaux de l’assemblée générale des actionnaires seront signés par le bureau de

l’assemblée. Les copies ou les extraits de ces procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le
Gérant.

VI. Exercice Comptable - Affectation des Bénéfices

Art. 19. Exercice comptable. L’exercice comptable de la Société débutera le premier (1 

er

 ) janvier et prendra fin le

trente et un (31) décembre chaque année.

Art. 20. Comptes, affectation des bénéfices.
20.1. Il incombera au Gérant d’établir le bilan annuel et le compte des profits et pertes de la Société conformément

aux dispositions de la loi applicable. Ces comptes seront soumis à l’approbation de l’assemblée des actionnaires.

139465

L

U X E M B O U R G

20.2. Il sera prélevé sur les bénéfices nets annuels de la Société un montant égal à cinq pour cent (5%) qui sera affecté

à la réserve légale. Cette affectation cessera d’être obligatoire lorsque cette réserve sera égale à dix pour cent (10%) du
capital social émis de la Société.

20.3. Le solde pourra faire l’objet d’une distribution de dividendes aux actionnaires sur proposition du Gérant qui

devra être approuvée par l’assemblée générale des actionnaires conformément aux dispositions prévues par les présents
Statuts, étant entendu que cette distribution ne pourra pas dépasser le montant proposé par le Gérant.

20.4. Des acomptes sur dividendes peuvent être déclarés et payés par le Gérant sous réserve du respect des conditions

prévues par la Loi.

20.5. Le compte de prime d’émission peut être distribué aux actionnaires sur proposition du Gérant qui sera approuvée

par une résolution de l’assemblée générale des actionnaires. L’assemblée générale des actionnaires peut, sur proposition
du Gérant, décider de prélever tout montant du compte de prime d’émission pour l’affecter au compte de réserve légale.

VII. Dissolution - Liquidation

Art. 21. Nomination des liquidateurs. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par les soins d’un

liquidateur (s’il s’agit d’une personne morale) ou d’un ou de plusieurs liquidateurs (s’il s’agit de personnes physiques)
nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui statue sur cette dissolution sur proposition du Gérant. Cette
assemblée déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.

Art. 22. Distribution des produits de la liquidation. Les produits nets de la liquidation devront être versés aux déten-

teurs d’Actions Ordinaires et au détenteur de l’Action de Commandité au prorata de leur actionnariat respectif étant
entendu que les Actions Ordinaires et l’Action de Commandité auront les mêmes droits.

VIII. Dispositions générales

Art. 23. Droit applicable. Tous les sujets qui ne sont pas régis par les présents Statuts seront déterminés conformément

à la Loi.

<i>Disposition transitoire

1. Le premier exercice social commencera à la date du présent acte et se terminera le 31 décembre 2014.
2. La première assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra en 2015.
3. Des acomptes sur dividendes pourront être distribués lors du premier exercice social de la Société.

<i>Souscription - Libération

1. Luxury Design Management, représentée comme indiqué ci-dessus, a déclaré souscrire à une (1) Action de Com-

mandité, sous forme nominative, ayant une valeur nominale de dix cents (EUR 0,10), et la libérer intégralement par un
apport en numéraire d’un montant de dix cents (EUR 0,10).

2. Luxury Design, représentée comme indiqué ci-dessus, a déclaré souscrire à trois cent neuf mille neuf cent quatre-

vingt-dix-neuf (309.999) Actions Ordinaires, sous forme nominative, ayant une valeur nominale de dix cents (EUR 0,10)
chacune, et les libérer intégralement par un apport en numéraire d’un montant de trente mille neuf cent quatre-vingt-
dix-neuf euros et quatre-vingt-dix cents (EUR 30.999,90).

Le montant de trente et un mille euros (EUR 31.000) est à la disposition de la Société, dont la preuve a été apportée

au notaire instrumentant par un certificat de blocage, qui le reconnaît expressément.

<i>Déclaration

Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées aux articles 26, 26-3 et 26-5

de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Les dépenses, frais, honoraires et charges de quelque nature que ce soit qui incomberont à la Société du fait de sa

constitution sont estimés à environ EUR 1.500,-

<i>Résolutions des actionnaires

Immédiatement après la constitution de la Société, Luxury Design Management et Luxury Design, étant les actionnaires

de la Société qui représentent l’intégralité du capital social souscrit ont pris les résolutions suivantes:

1. L’entité suivante est nommée en qualité de réviseur d'entreprises agréé de la Société pour un mandat renouvelable

d'une durée de six(6) ans avec effet à la date du présent acte et jusqu'à la date de l’assemblée générale annuelle des
actionnaires de la Société appelée à se prononcer sur l’approbation des comptes annuels pour l’exercice social prenant
fin le 31 décembre 2019:

KPMG Luxembourg, ayant son siège social au 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre

de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 149.133.

2. Le siège social de la Société est fixé au 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Le notaire instrumentant a rendu les parties attentives à la nécessité de nommer un représentant permanent du Gérant.

139466

L

U X E M B O U R G

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la requête des parties

comparantes ci-dessus, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et qu’en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, rédigé et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire, ce dernier a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.
Signé: T. SONMEZ et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 5 août 2014. Relation: LAC/2014/37097. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 20 août 2014.

Référence de publication: 2014131943/547.
(140149463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2014.

Nexus Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4-6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 189.588.

STATUTES

In the year two thousand and fourteen, on the eighth day of August.
Before us, Maître Loesch, notary residing at Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Nexus Holding AB, a company incorporated under the laws of Sweden, having its registered office at 26 Telefonvägen,

126 26 Hägersten, Sweden, registered with the Swedish Trade and Companies Register under number 556777-3915.

here represented by Mr Frank Stolz-Page, private employee, residing professionally at 13, avenue François Clément

L-5612 Mondorf-les-Bains,

by virtue of a proxy under private seal given on 31 July 2014.
The said proxy signed "ne varietur" by the attorney and the undersigned notary will remain attached to the present

deed, in order to be recorded with it.

The appearing party represented as stated above has requested the undersigned notary, to state as follows the articles

of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. The name of the private limited liability company is "Nexus Luxembourg S.à r.l." (the “Company”). The

Company is a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg and, in particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the “Law”), and
these articles of association (the “Articles”).

Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-

bourg.

It may be transferred within the municipality by a resolution of the board of managers (the “Board”). The registered

office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the members, acting
in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a

resolution of the Board. Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events
have occurred or are imminent and that these developments or events may interfere with the normal activities of the
Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the regis-
tered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these circumstances. Such temporary
measures have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered
office, remains a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Corporate object.
3.2. The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial

139467

L

U X E M B O U R G

instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, manage-
ment and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio
of intellectual property rights of any nature or origin whatsoever. It may also conduct researches, develop and manage
IT programs or software. It may also sell IT programs or software.

It may open branches in Luxembourg and abroad.
3.3. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may acquire participations
in loans and/or lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries,
affiliated companies or to any other company which form part of the group of companies to which the Company belongs.
It may also give guarantees and grant securities interest in favor of third parties to secure its obligations or the obligations
of its subsidiaries, affiliated companies or any other company which form part of the group of companies to which the
Company belongs. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or over
some of its assets.

3.4. The Company may employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose of their

efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit, currency
exchange, interest rate risks and other risks.

3.5. The Company may generally carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem useful

in the accomplishment and development of its purposes.

Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited duration.
4.2. The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy

or any similar event affecting one or several members.

II. Capital - Corporate units

Art. 5. Capital.
5.1. The corporate capital is set at twelve thousand and five hundred Euros (EUR 12,500), represented by twelve

thousand and five hundred (12,500) corporate units in registered form, having a par value of one Euro (EUR 1) each, all
subscribed and fully paid-up.

5.2. The corporate capital may be increased or decreased in one or several times by a resolution of the members,

acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

Art. 6. Corporate units.
6.1. The corporate units are indivisible and the Company recognizes only one (1) owner per corporate unit. In case

of joint ownership on one or several corporate unit(s) the members shall designate one (1) owner by corporate unit.

6.2. Corporate units are freely transferable among members.
Where the Company has a sole member, corporate units are freely transferable to third parties.
Where the Company has more than one member, the transfer of corporate units (inter vivos) to third parties is subject

to the prior approval of the members representing at least three-quarters (3/4) of the corporate capital.

The transfer of corporate units by reason of death to third parties must be approved by the members representing

at least three-quarters (3/4) of the rights owned by the survivors.

A corporate unit transfer is only binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance

by, the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

6.3. A register of members is kept at the registered office and may be examined by each member upon request.
6.4. The Company may redeem its own corporate units provided that the Company has sufficient distributable reserves

for that purpose or if the redemption results from a reduction of the Company's corporate capital.

III. Management - Representation

Art. 7. Appointment and Removal of managers.
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the members, which sets the

term of their office. The managers need not be members.

7.2. The managers may be removed at any time (with or without cause) by a resolution of the members.

Art. 8. Board of managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers (the

“Board”). The member(s) may decide to qualify the appointed managers as category A managers (the “Category A Ma-
nagers”) and category B managers (the “Category B Managers”).

8.1. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the member(s) by the Law or the Articles fall within the competence of the

Board, who has all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the corporate object.

(ii) Special and limited powers may be delegated for specific matters to one or more agents by the Board.

139468

L

U X E M B O U R G

(iii) The Board may from time to time sub-delegate its powers for specific tasks to one or several ad hoc agent(s) who

need not be member(s) or manager(s) of the Company. The Board will determine the powers, duties and remuneration
(if any) of its agent(s), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.

8.2. Procedure
(i) The Board meets upon the request of any manager, at the place indicated in the convening notice which, in principle,

is in Luxembourg.

(ii) Written notice of any meeting of the Board is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance,

except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.

(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and if they state to have full knowledge

of the agenda of the meeting. Notice of a meeting may also be waived by a manager, either before or after a meeting.
Separate written notices are not required for meetings that are held at times and places indicated in a schedule previously
adopted by the Board.

(iv) A manager may grant a power of attorney to another manager in order to be represented at any meeting of the

Board.

(v) The Board can deliberate or act validly only if a majority of the managers is present or represented at a meeting

of the board of managers, including at least one Category A Manager and one Category B Manager in the case that the
member(s) has(have) qualified the managers as Category A Managers and Category B Managers. Decisions shall be taken
by a majority vote of the managers present or represented at such meeting, including at least one vote of a Category A
Manager and one vote of a Category B Manager in the case that the member(s) has(have) qualified the managers as
Category A Managers and Category B Managers.

(vi) The resolutions of the meeting of the Board are taken in written form and reported on minutes. Such minutes are

signed by all the managers present.

(vii) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference or by any other means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. The
participation by these means is deemed equivalent to a participation in person at a meeting duly convened and held. The
meeting will be dated as at the date of the holding. The decision will also be valid as the date of the holding. The minutes
will be signed later by the manager participating to the Board by such means.

(viii) Circular resolutions signed by all the managers (the “Managers Circular Resolutions”), are valid and binding as if

passed at a Board meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.

8.3. Representation
(i) The Company shall be bound towards third parties in all matters by the sole signature of any manager or the joint

signature of any Category A Manager and any Category B Manager of the Company in the case that the member(s) has
(have) qualified the managers as Category A Managers and Category B Managers or by the joint or single signatures of
any persons to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with articles 8.1. (ii) and 8.3 (ii) of
these Articles.

(ii) The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have

been delegated by the Board.

Art. 9. Sole manager.
9.1 If the Company is managed by a sole manager, any reference in the Articles to the Board or the managers is to be

read as a reference to such sole manager, as appropriate.

9.2. The Company is bound towards third parties by the signature of the sole manager.
9.3. The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have

been delegated.

Art. 10. Liability of the managers. The managers may not, by reason of their mandate, be held personally liable for any

commitments validly made by them in the name of the Company, provided such commitments comply with the Articles
and the Law.

IV. Member(s)

Art. 11. General meetings of members and Members circular resolutions.
11.1. Powers and voting rights
(i) Resolutions of the members are adopted at a general meeting of members (the “General Meeting”) or by way of

circular resolutions (the “Members Circular Resolutions”) in case the number of members of the Company is less or
equal to twenty-five.

(ii) Where resolutions are to be adopted by way of Members Circular Resolutions, the text of the resolutions is sent

to all the members, in accordance with the Articles. In such case, each Member shall give his vote in writing. If passed,
Members Circular Resolutions are valid and binding as if passed at a General Meeting duly convened and held and bear
the date of the last signature.

(iii) Each corporate unit entitles to one (1) vote.

139469

L

U X E M B O U R G

11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The members are convened to General Meetings or consulted in writing at the initiative of any manager or members

representing more than one-half (1/2) of the corporate capital.

(ii) Written notice of any General Meeting is given to all members at least eight (8) calendar days in advance of the

date of the meeting, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of
the meeting.

(iii) General Meetings are held at such place and time specified in the notices.
(iv) If all the members are present or represented and consider themselves as duly convened and informed of the

agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice.

(v) A member may grant a written power of attorney to another person, whether or not a member, in order to be

represented at any General Meeting.

(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Members Circular Resolutions are passed by members

owning more than one-half (1/2) of the corporate capital. If this majority is not reached at the first General Meeting or
first written consultation, the members are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted a
second time and the resolutions are adopted at the General Meeting or by Members Circular Resolutions by a majority
of the votes cast, regardless of the proportion of the corporate capital represented.

(vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of members owning at least three-quarters

(3/4) of the corporate capital.

(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase of a member's commitment in the Company

require the unanimous consent of the members.

Art. 12. Sole member.
12.1. Where the number of members is reduced to one (1), the sole member exercises all powers conferred by the

Law to the General Meeting.

12.2. Any reference in the Articles to the members and the General Meeting or to Members Circular Resolutions is

to be read as a reference to such sole member or the resolutions of the latter, as appropriate.

12.3. The resolutions of the sole member are recorded in minutes or drawn up in writing.

V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision

Art. 13. Financial year and Approval of annual accounts.
13.1. The financial year begins on the first (1 

st

 ) of January of each year and ends on the thirty-first (31) of December

of the same year.

13.2. Each year, the Board prepares the balance sheet and the profit and loss account, as well as an inventory indicating

the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarizing the Company's commitments and the debts
of the manager(s) and members towards the Company.

13.3. Each member may inspect the inventory and the balance sheet at the registered office.
13.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Members

Circular Resolutions within six (6) months from the closing of the financial year.

13.5. In case the number of members of the Company exceeds twenty-five (25), the annual General Meeting shall be

held each year on the third Tuesday of June each year at 3.00 pm at the registered office of the Company, and if such day
is not a day on which banks are opened for general business in the city of Luxembourg (i.e. a “Business Day”), on the
next following Business Day at the same time and place.

Art. 14. Statutory auditor(s) (Commissaire(s)) - Independent auditor(s) (Réviseur(s) d'entreprises agréé(s)).
14.1. In case the number of members of the Company exceeds twenty-five (25), the supervision of the Company shall

be entrusted to one or more statutory auditor(s) (commissaire(s)), who may or may not be members.

14.2. The operations of the Company are supervised by one or several independent auditor(s) (réviseur(s) d'entre-

prises agréé(s)), when so required by law.

14.3. The members appoint the statutory auditor (commissaire), if any and independent auditor (réviseur d'entreprises

agréé(s)), if any, and determine their number, remuneration and the term of their office, which may not exceed six (6)
years. The statutory auditor (commissaire) and the independent auditor (réviseur d'entreprises agréé(s)) may be reap-
pointed.

Art. 15. Allocation of profits.
15.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) is allocated to the reserve required by Law. This

allocation ceases to be required when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the corporate
capital.

15.2. The members determine how the balance of the annual net profits is disposed of. It may allocate such balance

to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward.

139470

L

U X E M B O U R G

15.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) interim accounts are drawn up by the Board;
(ii) these interim accounts show that sufficient profits and other available reserves (including share premium) are

available for distribution; and

(iii) the decision to distribute interim dividends must be taken by the Board within two (2) months from the date of

the interim accounts.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16.
16.1. The Company may be dissolved at any time, by a resolution of the members, adopted by one-half (1/2) of the

members holding three-quarters (3/4) of the corporate capital. The members appoint one or several liquidators, who
need  not  be  members,  to  carry  out  the  liquidation  and  determine  their  number,  powers  and  remuneration.  Unless
otherwise decided by the members, the liquidators have the broadest powers to realize the assets and pay the liabilities
of the Company.

16.2. The surplus after the realization of the assets and the payment of the liabilities is distributed to the members in

proportion to the corporate units held by each of them.

VII. General provisions

Art. 17.
17.1. Notices and communications are made or waived and the Managers Circular Resolutions as well as the Members

Circular Resolutions are evidenced in writing, by telegram, telefax, e-mail or any other means of electronic communica-
tion.

17.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with

Board meetings may also be granted by a manager in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfill all legal requirements to be deemed

equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers Circular Resolutions or the Members Circular Resolu-
tions, as the case may be, are affixed on one original or on several counterparts of the same document, all of which taken
together constitute one and the same document.

17.4. All matters not expressly governed by the Articles are determined in accordance with the Law and, subject to

any non waiver provisions of the law, any agreement entered into by the members from time to time.

<i>Transitory provision

The first financial year begins on the date of this deed and ends on December 31, 2014.

<i>Subscription and Payment

Nexus  Holding  AB,  prenamed,  represented  as  stated  above,  subscribes  all  the  twelve  thousand  and  five  hundred

(12,500) corporate units.

The amount of twelve thousand and five hundred Euros (EUR 12,500) is at the disposal of the Company, evidence of

which has been given to the undersigned notary.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its

incorporation are estimated at approximately one thousand seven hundred fifty Euro (EUR 1,750).

<i>Resolutions of the sole member

Immediately  after  the  incorporation  of  the  Company,  the  sole  member  of  the  Company,  representing  the  entire

subscribed capital, has passed the following resolutions:

1. The following persons are appointed as managers of the Company for an unlimited period:

- Jan Peter Gille, born in Uppsala, on August 21 

st

 1962, residing at Urdavägen 16, 182 54 Djursholm, Sweden as

category A manager of the Company.

- Björn Christer Johansson, born in Malmö, on March 15 

th

 1957, residing at Fritzbergsvägen 172 F, 186 49 Vallentuna,

Sweden as category B manager of the Company.

- Per Anders Hägerö, born in Stockholm, on August 14 

th

 1972, residing at Ruddammsvägen 37, 114 21 Stockholm,

Sweden as category B manager of the Company.

2. The registered office of the Company is set at 2-4-6, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of

Luxembourg.

139471

L

U X E M B O U R G

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that, on the request of the appearing party, this

deed is drawn up in English, followed by a French version and, in case of divergences between the English text and the
French text, the English text prevails.

WHEREOF, this deed was drawn up in Mondorf-les-Bains, at the office of the undersigned notary, on the day stated

above.

This deed has been read to the representative of the appearing party, and signed by the latter with the undersigned

notary.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le huit août.
Par devant Maître Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-duché de Luxembourg.

A COMPARU:

Nexus Holding AB, une société constituée sous les lois de la Suède, ayant son siège social à 26 Telefonvägen, 126 26

Hägersten, Suède, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de la Suède sous le numéro 556777-3915,

ici représentée par Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, demeurant professionnellement au 13, avenue François

Clément à L-5612 Mondorf-les-Bains,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, en date du 31 juillet 2014.
La prédite procuration, signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte avec lequel elle sera enregistrée.

La partie comparante, représentée comme établit ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire de documenter comme

suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle constitue par la présente:

I. Dénomination - Siège social - Objet- Durée

Art. 1 

er

 . Dénomination.  Le nom de la société à responsabilité limitée est "Nexus Luxembourg S.à r.l." (la «Société»).

La Société est une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-duché de Luxembourg, et en particulier par
la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), ainsi que par les présents statuts (les
«Statuts»).

Art. 2. Siège social.
2.1 Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il peut être transféré dans la commune par décision du conseil de gérance (le «Conseil»). Le siège social peut être

transféré en tout autre endroit du Grand-duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités
requises pour la modification des Statuts.

2.2 Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-duché de Luxembourg qu'à l'étranger

par décision du Conseil.

Lorsque le Conseil estime que des développements ou événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire se

sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou évènements sont de nature à compromettre les activités
normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger, le siège social peut
être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances. Ces mesures provisoires
n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son siège social, reste une
société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social.
3.1. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans d'autres sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir
par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation,
obligations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité
publique ou privée. Elle pourra participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société
ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de droits de propriété intel-
lectuelle de quelque nature ou origine que ce soit. Elle pourra effectuer de la recherche et du développement afin de
créer, gérer, mettre en valeur des programmes ou des logiciels informatiques. Elle pourra également effectuer la vente
des programmes ou des logiciels informatiques.

Elle pourra créer des succursales à Luxembourg et à l'étranger.
3.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle pourra procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l'émission d'actions et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts
et/ou de créances. La Société pourra acquérir des participations dans des prêts et/ou prêter des fonds, y compris ceux
résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations, à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société qui fait
partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société. Elle pourra également consentir des garanties et des sûretés

139472

L

U X E M B O U R G

au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute
autre société qui fait partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société. La Société pourra en outre nantir, céder,
grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie
de ses avoirs.

3.3. La Société pourra employer toutes techniques et instruments liés à ses investissements en vue d'une gestion

efficace, y compris des techniques et instruments destinés à protéger la Société contre le risque crédit, le risque de change,
de fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

3.4. La Société pourra, d'une manière générale, réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, qui

lui sembleront nécessaires à l'accomplissement et au développement de son objet.

Art. 4. Durée.
4.1 La Société est formée pour une durée illimitée.
4.2 La Société n'est pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insolvabilité,

de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital.
5.1 Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par douze mille cinq cents (12.500)

parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale d’un euro (EUR 1) chacune, toutes souscrites et entiè-
rement libérées.

5.2 Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée

selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales.
6.1 Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale. En cas

d’indivision sur une ou plusieurs part(s) sociale(s) les associés désigneront un (1) propriétaire par part sociale.

6.2 Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.
Lorsque la Société a plus d'un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l'accord

préalable des associés représentant au moins les trois-quarts (3/4) du capital social.

La cession de parts sociales à un tiers par suite du décès doit être approuvée par les associés représentant les trois-

quarts (3/4) des droits détenus par les survivants.

Une cession de parts sociales n'est opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la Société

ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil.

6.3 Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.
6.4 La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition que la Société ait des réserves distribuables suffi-

santes à cet effet ou que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Nomination et révocation des gérants.
7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur

mandat. Les gérants ne doivent pas obligatoirement être associés.

7.2 Les gérants sont révocables à tout moment (avec ou sans raison) par une décision des associés.

Art. 8. Conseil de gérance. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent le conseil de gérance (le «Conseil»). Les

associés peuvent décider de nommer les gérants en tant que gérant(s) de catégorie A (les «Gérants de Catégorie A») et
gérant(s) de catégorie B (les «Gérants de Catégorie B»).

8.1 Pouvoirs du conseil de gérance
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à ou aux associés sont de la compétence du

Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.

(ii) Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches

spécifiques.

(iii) Le Conseil peut ponctuellement subdéléguer ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad

hoc, le(s)quel(s) peut (peuvent) ne pas être associé(s) ou gérant(s) de la Société. Le Conseil détermine les responsabilités
et la rémunération (s'il y a lieu) de ce(s) agent(s), la durée de son/leur mandat(s) ainsi que toutes autres conditions de
son/leur mandat(s).

8.2 Procédure
(i) Le Conseil se réunit sur convocation d’un gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en principe, est au

Luxembourg.

139473

L

U X E M B O U R G

(ii) Il est donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24)

heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées dans
la convocation à la réunion.

(iii) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et s'ils déclarent

avoir parfaitement eu connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation
à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des
réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixées dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.
(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

comprenant au moins un Gérant de Catégorie A et un Gérant de Catégorie B si les gérants sont nommés en tant que
Gérants de Catégorie A et Gérants de Catégorie B. Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité
des voix des gérants présents ou représentés, comprenant au moins un vote d’un Gérant de Catégorie A et un vote d’un
Gérant de Catégorie B si les gérants sont nommés en tant que Gérants de Catégorie A et Gérants de Catégorie B.

(vi) Les résolutions de la réunion du Conseil sont prises par écrit et inscrites sur un procès-verbal. Ce procès-verbal

est signé par tous les gérants présents.

(vii) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visioconférence ou par tout autre moyen

de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se
parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement con-
voquée et tenue. La réunion du Conseil sera datée à la date de sa tenue. Les résolutions seront également valables au
jour de la réunion. Le procès-verbal sera signé plus tard par le gérant participant au Conseil par de tels moyens.

(viii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (les «Résolutions Circulaires des Gérants») sont valables

et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue
et portent la date de la dernière signature.

8.3 Représentation
(i) La Société sera engagée, en tout circonstance, vis-à-vis des tiers par la signature seule de tout gérant, ou les signatures

conjointes d’un Gérant de Catégorie A et d’un Gérant de Catégorie B si les gérants sont nommés en tant que Gérants
de Catégorie A et Gérants de Catégorie B, ou par les signatures conjointes ou la signature unique de toutes personnes
à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément aux articles 8.1. (ii) et 8.3 (ii) des Statuts.

(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux

ont été délégués par le Conseil.

Art. 9. Gérant unique.
9.1 Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux gérants doit être

considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.

9.2 La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature du gérant unique.
9.3 La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux

ont été délégués.

Art. 10. Responsabilité des gérants. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle

concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
conformes aux Statuts et à la Loi.

IV. Associé(s)

Art. 11. Assemblées générales des associés et résolutions circulaires des associés.
11.1 Pouvoirs et droits de vote
(i) Les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés (l' «Assemblée Générale») ou par

voie de résolutions circulaires (les «Résolutions Circulaires des Associés») dans le cas où le nombre d'associés est égal
ou moindre que vingt-cinq (25).

(ii) Dans le cas où les résolutions sont adoptées par Résolutions Circulaires des Associés, le texte des résolutions est

communiqué à tous les associés, conformément aux Statuts. Dans un tel cas, chaque associé doit donner son vote par
écrit. Si elles sont adoptées, les Résolutions Circulaires des Associés sont valables et engagent la Société comme si elles
avaient été adoptées lors d'une Assemblée Générale valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière
signature.

(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
11.2 Convocations, quorum, majorité et procédure de vote
(i) Les associés sont convoqués aux Assemblées Générales ou consultés par écrit à l'initiative de tout gérant ou des

associés représentant plus de la moitié (1/2) du capital social.

(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant

la date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence sont précisées
dans la convocation à ladite assemblée.

139474

L

U X E M B O U R G

(iii) Les Assemblées Générales seront tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.
(iv) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et

informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.

(v) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à

toute Assemblée Générale.

(vi) Les décisions à adopter par l'Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des Associés sont adoptées par

des associés détenant plus de la moitié (1/2) du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée
Générale ou première consultation écrite, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée
Générale ou consultés une seconde fois, et les décisions sont adoptées par l'Assemblée Générale ou par Résolutions
Circulaires des Associés à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.

(vii) Les Statuts sont modifiés avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les

trois-quarts (3/4) du capital social.

(viii) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la

Société exige le consentement unanime des associés.

Art. 12. Associé unique.
12.1 Si le nombre des associés est réduit à un (1), l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à

l'Assemblée Générale.

12.2 Toute référence dans les Statuts aux associés et à l'Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des

Associés doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l'associé unique ou aux résolutions de ce dernier.

12.3 Les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle

Art. 13. Exercice social et Approbation des comptes annuels.

13.1 L'exercice social commence le premier (1 

er

 ) janvier de chaque année et se termine le trente et un (31) décembre

de la même année.

13.2 Chaque année, le Conseil dresse le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur

des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes du ou des
gérants et des associés envers la Société.

13.3 Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social.
13.4 Le bilan et le compte de profits et pertes sont approuvés par l'Assemblée Générale annuelle ou par Résolutions

Circulaires des Associés dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice social.

13.5 Lorsque le nombre d'associés de la Société excède vingt-cinq (25) associés, l'Assemblée Générale annuelle doit

se tenir chaque année le troisième mardi du mois de juin à 15.00 heures au siège social de la Société, et si ce jour n'est
pas un jour ouvrable pour les banques à Luxembourg (un «Jour Ouvrable»), le Jour Ouvrable suivant à la même heure et
au même lieu.

Art. 14. Commissaire(s) - Réviseur(s) d'entreprises agréé(s).
14.1 Lorsque le nombre d'associés de la Société excède vingt-cinq (25) associés, les opérations de la Société sont

contrôlées par un ou plusieurs commissaire(s), qui peuvent être associés ou non.

14.2 Les opérations de la Société seront supervisées par un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprise agréé(s), dans les cas

prévus par la loi.

14.3 Les associés devront nommer le(s) commissaire(s) / réviseur(s) d'entreprise agréé(s) et déterminer leur nombre,

leur rémunération et la durée de leur mandat, lequel ne pourra dépasser six (6) ans. Le(s) commissaire(s) / réviseur(s)
d'entreprise agréé(s) pourront être réélus.

Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1 Cinq pour cent (5%) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi. Cette

affectation cesse d'être exigée quand la réserve légale atteint dix pour cent (10%) du capital social.

15.2 Les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au

paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter.

15.3 Des dividendes intérimaires peuvent être distribués, à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;
(ii)  ces  comptes  intérimaires  montrent  que  des  bénéfices  et  autres  réserves  disponibles  (en  ce  compris  la  prime

d'émission) suffisants sont disponibles pour une distribution; et

(iii) la décision de distribuer des dividendes intérimaires doit être adoptée par le Conseil dans les deux (2) mois suivant

la date des comptes intérimaires.

139475

L

U X E M B O U R G

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16.
16.1 La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la moitié (1/2) des

associés détenant les troisquarts (3/4) du capital social. Les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont pas
besoin d'être associés, pour réaliser la liquidation et déterminent leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf décision
contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer les
dettes de la Société.

16.2 Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes est distribué aux associés propor-

tionnellement aux parts sociales détenues par chacun d'entre eux.

VII. Dispositions générales

Art. 17.
17.1 Les convocations et communications, respectivement les renonciations à celles-ci, sont faites, et les Résolutions

Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Circulaires des Associés sont établies par écrit, télégramme, téléfax, e-
mail ou tout autre moyen de communication électronique.

17.2 Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus.
Les procurations relatives aux réunions du Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux

conditions acceptées par le Conseil.

17.3 Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions légales

pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants ou des Réso-
lutions Circulaires des Associés, selon le cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document,
qui ensemble, constituent un seul et unique document.

17.4 Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la Loi et, sous réserve des

dispositions légales d'ordre public, à tout accord conclu de temps à autre entre les associés.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date du présent acte et s'achève le 31 décembre 2014.

<i>Souscription et Libération

Nexus Holding AB, prénommée, représentée comme indiqué ci-dessus, souscrit toutes les douze mille cinq cents

(12.500) parts sociales.

Le montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) est à la disposition de la Société, comme il a été prouvé au

notaire instrumentant, qui le confirme expressément.

<i>Frais

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution

s'élèvent approximativement à mille sept cent cinquante euros (EUR 1.750).

<i>Résolutions de l'associé unique

Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique de la Société, représentant l'intégralité du capital

social souscrit, a pris les résolutions suivantes:

1. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Jan Peter Gille, né à Uppsala, le 21 août 1962, résidant à Urdavägen 16, 182 54 Djursholm, Suède comme gérant de

catégorie A de la Société.

- Björn Christer Johansson, né Malmö, le 15 Mars 1957, résidant à Fritzbergsvägen 172 F, 186 49 Vallentuna, Suède

comme gérant de catégorie B de la Société.

- Per Anders Hägerö, né Stockholm, le 14 août 1972, résidant à Ruddammsvägen 37, 114 21 Stockholm, Suède comme

gérant de catégorie B de la Société.

2. Le siège social de la Société est établi 2-4-6, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-

bourg).

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que, à la requête de la partie comparante, le présent acte

est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et que, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français,
la version anglaise fait foi.

Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l'étude du notaire soussigné, à la date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé avec le notaire instru-

mentant, le présent acte.

139476

L

U X E M B O U R G

Signé: F. Stolz-Page, M. Loesch.
Enregistré à Remich, le 11 août 2014. REM/2014/1771. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 20 août 2014.

Référence de publication: 2014132006/536.
(140149625) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2014.

Life Bond Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 189.613.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendvierzehn am zwölften August.
Vor dem unterzeichnenden Maître Francis KESSELER, Notar mit Amtssitz in Esch-sur-Alzette, Großherzogtum Lu-

xemburg,

IST ERSCHIENEN:

Life Bond Holding GmbH &amp; Co KG, eine ordnungsgemäß nach deutschem Recht errichtete Gesellschaft mit einge-

tragenem Sitz in Münchener Straße 54, D-82069 Hohenschäftlarn und eingetragen im Registergericht München unter der
Nummer HRA 88777, vertreten durch Michael G. Hoesch und Ulrich Lewandowski,

diese vertreten durch Marcus PETER, Rechtsanwalt, beruflich ansässig in Luxemburg, per Vollmacht erteilt in Hohen-

schäftlarn am 12. August 2014.

Die vorgenannte Vollmacht wird, nachdem sie “ne varietur” durch den Vertreter der erschienenen Partei und durch

den unterzeichnenden Notar unterschrieben wurde, dieser notariellen Urkunde zum Zweck der Registrierung beigefügt
bleiben.

Die erschienene Partei, vertreten wie oben angegeben, hat den unterzeichnenden Notar gebeten, wie folgt die Satzung

einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) festzustellen, die hiermit gegründet wird:

„I. Name - Sitz - Gesellschaftszweck - Dauer

Art. 1. Name. Der Name der Gesellschaft lautet Life Bond Lux S.à r.l. (die “Gesellschaft”). Die Gesellschaft ist eine

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) nach dem Recht des Großherzogtums Luxem-
burgs und insbesondere dem Gesetz über Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 in seiner jeweils aktuellen Fassung
(das “1915 Gesetz”) sowie dieser Satzung (die “Satzung”).

Art. 2. Sitz.
2.1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Niederanven (Senningerberg), Großherzogtum Luxem-

burg.  Er  darf  innerhalb  der  Gemeinde  Niederanven  durch  Beschluss  des  Geschäftsführers  oder  des  Vorstands  der
Gesellschaft (der “Vorstand”) verlegt werden. Der Sitz kann durch Beschluss der Gesellschafter im Einklang mit den
Vorschriften, welche für eine Satzungsänderung gelten, an einen anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt
werden.

2.2. Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften oder andere Niederlassungen können durch Beschluss des Vorstands

im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland begründet werden. Bestimmt der Vorstand, dass außergewöhnliche
politische oder militärische Entwicklungen oder Ereignisse aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen und dass diese
Entwicklungen die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem Sitz oder die Kommunikation mit dem Ausland
erschweren könnten, darf der Sitz vorübergehend ins Ausland verlegt werden, bis diese Umstände nicht mehr bestehen.
Solche vorübergehenden Maßnahmen haben keine Auswirkung auf die Nationalität der Gesellschaft, die, ungeachtet der
vorübergehenden Verlegung des Sitzes, eine nach luxemburgischem Recht gegründete Gesellschaft bleibt.

Art. 3. Gesellschaftszweck.
3.1. Der Zweck der Gesellschaft ist die gesetzliche Vertretung als geschäftsführende Komplementärin und persönlich

haftende Gesellschafterin der Life Bond US 2.0 SCSp, eine Gesellschaft in Form einer speziellen Kommanditgesellschaft
(société en commandite spéciale).

3.2 Der Gegenstand der Gesellschaft liegt des Weiteren im Erwerb und Halten von Beteiligungen, direkt oder indirekt,

in irgendeiner Form in anderen luxemburgischen oder ausländischen Unternehmen, durch, unter anderem, die Zeichnung
oder den Erwerb von Wertpapieren und Rechten durch Beteiligung, Einlage, Übernahme einer Emission, Kauf oder Kau-
foption, Verhandlungen oder auf andere Weise, oder von Finanzschuldinstrumenten in welcher Form auch immer, und
solche Beteiligungen zu verwalten, zu entwickeln und zu administrieren.

3.3 Die Gesellschaft kann in der Begründung und Entwicklung finanzieller, industrieller und wirtschaftlicher Gesell-

schaften jeglicher Gesellschaftsform partizipieren.

139477

L

U X E M B O U R G

3.4 Die Gesellschaft kann an Gesellschaften der Unternehmensgruppe Geld verleihen und kann sich selbst Geld leihen

von Gesellschaftern und/oder Dritten und jeweils Garantien oder anderweitige Kreditsicherungen gewähren.

3.5 Die Gesellschaft darf ihre Forderungen den Forderungen Dritter gegenüber solchen Gesellschaften und Unter-

nehmungen nachordnen.

3.6. Zusätzlich zu dem Vorangegangenen darf die Gesellschaft alle rechtlichen, wirtschaftlichen, technischen und fi-

nanziellen Transaktionen und allgemein sowohl jede Handlung vornehmen, die notwendig oder nützlich ist, um ihren
Gesellschaftszweck zu erreichen, als auch jede Transaktion, die direkt oder indirekt mit den oben beschriebenen Gebieten
in Verbindung steht, um die Erreichung des Gesellschaftszwecks in allen oben genannten Gebieten zu erleichtern, durch-
führen.

Art. 4. Dauer.
4.1. Die Gesellschaft ist auf unbeschränkte Dauer gegründet.
4.2. Die Gesellschaft wird nicht durch Tod, Aufhebung der Grundrechte, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Insolvenz,

Zahlungsunfähigkeit oder durch ein ähnliches Ereignis, welches einen oder mehrere Gesellschafter betrifft, aufgelöst.

II. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1. Das Gesellschaftskapital beträgt achtzehntausendfünfhundert US-Dollar (USD 18.500.-), eingeteilt in achtzehn-

tausendfünfhundert (18.500) Anteile zu einem Nennwert von je einem US-Dollar (USD 1.-), die vollständig gezeichnet
und bezahlt wurden.

5.2. Das Gesellschaftskapital kann durch Beschluss der Gesellschafter erhöht oder verringert werden unter Anwendung

der Bestimmungen, die für die Änderung der Satzung gelten.

Art. 6. Anteile.
6.1. Anteile sind unteilbar. Die Gesellschaft erkennt nur einen (1) Inhaber pro Anteil an. Anteile werden nur in regis-

trierter Form ausgegeben.

6.2. Anteile sind unter den Gesellschaftern frei übertragbar. Hat die Gesellschaft nur einen Gesellschafter, sind die

Anteile an Dritte frei übertragbar.

Hat die Gesellschaft mehr als einen Gesellschafter, bedarf die Übertragung von Anteilen (inter vivos) an Dritte des

vorherigen Einverständnisses der Gesellschafter, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.

Der Übertragung von Anteilen aufgrund des Todes eines Gesellschafters an Dritte muss durch Gesellschafter zuges-

timmt werden, die drei Viertel des Gesellschaftskapitals der Überlebenden vertreten.

Eine Übertragung von Anteilen ist für die Gesellschaft oder Dritte nur bindend, wenn ihr die Mitteilung an oder die

Annahme durch die Gesellschaft gemäß Artikel 1690 des Zivilgesetzbuchs folgt.

6.3. Am Sitz der Gesellschaft wird ein Gesellschafterregister verwahrt, welches auf Antrag durch jeden Gesellschafter

eingesehen werden darf.

6.4. Die Gesellschaft kann eigene Anteile zurückkaufen, sofern sie ausreichende verteilungsfähige Reserven zu diesem

Zweck besitzt oder wenn die Rücknahme der Anteile aus einer Reduktion des Gesellschaftskapitals resultiert.

III. Geschäftsführung - Vertretung

Art. 7. Ernennung und Abberufung der Geschäftsführer.
7.1. Die Gesellschaft wird von mehreren Geschäftsführern, welche durch Beschluss der Gesellschafter, der die Dauer

ihres Mandats bestimmt, ernannt werden, verwaltet.

7.2. Die Geschäftsführer können jederzeit mit oder ohne Grund durch Beschluss der Gesellschafter abberufen werden.

Art. 8. Vorstand. Wenn mehrere Geschäftsführer ernannt wurden, bilden die Geschäftsführer zusammen den Vors-

tand.

8.1 Befugnisse des Vorstands
(i) Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das 1915 Gesetz oder diese Satzung den Gesellschaftern vorbehalten

ist, unterliegen der Zuständigkeit des Vorstands, der mit den größtmöglichen Befugnissen ausgestattet ist, um sämtliche
Handlungen zur Verwaltung und Geschäftstätigkeit der Gesellschaft auszuführen und zu genehmigen, die dem Gesell-
schaftszweck dienen.

(ii) Der Vorstand kann seine Zuständigkeiten für spezielle Aufgaben an einen oder mehrere Vertreter delegieren.
8.2. Verfahren
(i) Der Vorstand trifft sich auf Antrag eines Geschäftsführers an dem Ort, der in der Ladung angegeben ist, aber

ausschließlich in Luxemburg.

(ii) Alle Geschäftsführer erhalten mindestens vierundzwanzig Stunden im voraus eine schriftliche Ladung zu Sitzungen

des Vorstands per Brief, Fax, Email oder sonstiger elektronischer Kommunikation. Diese Frist gilt nicht in einem Notfall,
dessen Art und Umstände in der Ladung angegeben werden müssen.

139478

L

U X E M B O U R G

(iii) Eine Ladung ist nicht erforderlich, wenn alle Mitglieder des Vorstands anwesend oder vertreten sind und wenn sie

bestätigen, dass sie über vollständige Kenntnis der Tagesordnung der Sitzung verfügen. Ein Geschäftsführer kann auch
vor, während oder nach einer Sitzung auf die Ladung zu einer Sitzung verzichten. Separate schriftliche Ladungen sind nicht
erforderlich für Sitzungen, die zu Orten und Zeiten abgehalten werden, die in einem zuvor durch den Vorstand bes-
chlossenen Terminplan festgelegt worden sind.

(iv) Ein Geschäftsführer kann einem anderen Geschäftsführer Vertretungsmacht erteilen, damit er ihn in den Sitzungen

des Vorstands vertritt.

(v) Der Vorstand kann nur wirksam beraten und handeln, wenn eine Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder ver-

treten ist. Beschlüsse des Vorstands werden durch eine Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer
gefasst. Die Beschlüsse des Vorstands werden in einem Protokoll festgehalten, welches durch den Vorsitzenden der
Sitzung oder, wenn kein Vorsitzender ernannt wurde, durch alle anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer unter-
zeichnet wird.

(vi) Jeder Geschäftsführer darf an Sitzungen des Vorstands per Telefon- oder Videokonferenz oder per sonstiger

Kommunikation teilnehmen, die sämtlichen teilnehmenden Personen ermöglicht, einander zu identifizieren, zu hören und
zu sprechen. Eine solche Teilnahme steht einer Teilnahme in Person an einer ordnungsgemäß einberufenen und abge-
haltenen Sitzung gleich.

(vii) Von allen Geschäftsführern unterschriebene Umlaufbeschlüsse sind mit dem Datum der letzten Unterzeichnung

gültig und bindend als wenn sie in einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Sitzung gefasst worden wären.

8.3. Vertretung
(i) Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten in allen Angelegenheiten durch die gemeinsame Unterschrift von zwei

Geschäftsführern verpflichtet.

(ii) Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten auch durch die Unterschrift eines Bevollmächtigten, an den bestimmte

Befugnisse delegiert wurden, verpflichtet.

Art. 9. Alleiniger Geschäftsführer.
9.1. Wenn die Gesellschaft von nur einem Geschäftsführer verwaltet wird, gilt soweit angebracht, jede Bezugnahme

in dieser Satzung auf den Vorstand als Bezugnahme auf den alleinigen Geschäftsführer.

9.2 Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten in allen Angelegenheiten durch die Unterschrift des alleinigen Geschäfts-

führers gebunden.

9.3 Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten auch durch die Unterschrift eines Bevollmächtigten, an den bestimmte

Befugnisse delegiert wurden, verpflichtet.

Art. 10. Haftung der Geschäftsführer. Die Geschäftsführer können nicht aufgrund ihres Mandats persönlich für Verp-

flichtungen verantwortlich gemacht werden, die sie wirksam im Namen der Gesellschaft eingegangen sind, sofern diese
Verpflichtungen im Einklang mit der Satzung und mit dem 1915 Gesetz sind.

IV. Gesellschafter

Art. 11. Gesellschafterversammlung.
11.1. Entscheidungen der Gesellschafter werden in einer Gesellschafterversammlung oder durch schriftliche Beratung

auf Veranlassung des Vorstands hin getroffen.

11.2. Ein Beschluss ist wirksam gefasst, wenn er von Gesellschaftern gefasst wurde, die mehr als die Hälfte des Ge-

sellschaftskapitals  vertreten.  Wird  diese  Mehrheit  nicht  in  der  ersten  Gesellschafterversammlung  oder  in  der  ersten
schriftlichen  Beratung  erreicht,  werden  die  Gesellschafter  durch  per  Einschreiben  versandten  Brief  zu  einer  zweiten
Gesellschafterversammlung oder zu einer zweiten schriftlichen Beratung geladen, und die Beschlüsse werden wirksam
gefasst durch die Mehrheit der Stimmen, unabhängig von dem Anteil des vertretenen Gesellschaftskapitals.

11.3. Abweichend hiervon können Beschlüsse zur Abänderung dieser Satzung nur durch die Mehrheit der Gesell-

schafter gefasst werden, welche mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals besitzen, gemäß den Vorschriften des
1915 Gesetzes.

11.4 Eine Änderung der Nationalität der Gesellschaft und eine Erhöhung der Einlage eines Gesellschafters erfordern

die einstimmige Zustimmung aller Gesellschafter.

11.5 Ein Gesellschafter kann schriftlich einer anderen Person Vollmacht erteilen, unabhängig davon, ob diese Gesell-

schafter ist oder nicht, um sich in einer Gesellschafterversammlung vertreten zu lassen.

Art. 12. Alleiniger Gesellschafter.
12.1. Hat die Gesellschaft nur einen (1) Gesellschafter, übt der alleinige Gesellschafter alle Befugnisse aus, die gemäß

dem 1915 Gesetz der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind.

12.2. Jede Bezugnahme in der Satzung auf die Gesellschafter und die Gesellschafterversammlung ist, sofern anwendbar,

als Bezugnahme auf den alleinigen Gesellschafter oder Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters zu verstehen.

12.3. Die Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters werden durch ein Protokoll aufgezeichnet oder schriftlich festge-

halten.

139479

L

U X E M B O U R G

V. Jahresabschlüsse - Verteilung von Gewinnen - Aufsicht

Art. 13. Geschäftsjahr und Zustimmung zu Jahresabschlüssen.
13.1. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten (1.) Januar und endet am einunddreißigsten (31.) Dezember

eines jeden Jahres.

13.2. Jedes Jahr bereitet der Vorstand eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung vor sowie ein Inventar, das

den Wert der Aktiva und Verpflichtungen der Gesellschaft angibt, mit einem Anhang, welcher die Verpflichtungen der
Gesellschaft und die Schulden der Geschäftsführer gegenüber der Gesellschaft zusammenfasst.

13.3. Jeder Gesellschafter darf das Inventar und die Bilanz am Gesellschaftssitz einsehen.
13.4. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung werden durch die Gesellschafterversammlung innerhalb von

sechs (6) Monaten nach dem Abschluss des Geschäftsjahrs genehmigt.

Art. 14. Verteilung von Gewinnen.
14.1. Fünf Prozent (5 %) des Nettogewinns der Gesellschaft werden der gesetzlichen Reserve zugeführt. Diese Zu-

führung ist nicht mehr erforderlich, wenn die gesetzliche Reserve einen Betrag von zehn Prozent (10 %) des Gesell-
schaftskapitals umfasst.

14.2. Die Gesellschafter bestimmen, wie der verbleibende Überschuss der jährlichen Nettogewinne verwendet wird.

Er kann für die Zahlung einer Dividende verwendet werden, auf ein Reservekonto überwiesen oder auf das nächste
Geschäftsjahr übertragen werden.

14.3. Durch Entscheidung des Vorstands dürfen Zwischendividenden unter den folgenden Bedingungen jederzeit aus-

gezahlt werden:

(i) Der Vorstand erstellt Zwischenbilanzen;
(ii) diese Zwischenbilanzen zeigen, dass ausreichende Gewinne und andere Reserven (einschließlich Agio) für die Aus-

zahlung  zur  Verfügung  stehen;  dies  ist  so  zu  verstehen,  dass  der  auszuzahlende  Betrag  nicht,  sofern  vorhanden,  die
Gewinne übersteigen darf, die seit dem Ende des letzten Geschäftsjahres, für das der Jahresabschluss genehmigt wurde,
erwirtschaftet wurden, erhöht um den Betrag der vorgetragenen Gewinne und verteilungsfähiger Reserven, und vermin-
dert um vorgetragene Verluste und Beträge, die der gesetzlichen Reserve zuzuführen sind;

(iii) die Entscheidung, Zwischendividenden auszuzahlen, muss der Vorstand innerhalb von zwei (2) Monaten ab dem

Datum der Zwischenbilanzen treffen;

(iv) die Rechte der Gläubiger der Gesellschaft werden unter Berücksichtigung der Aktiva der Gesellschaft nicht ge-

fährdet; und

(v) sofern die Zwischendividenden die verteilungsfähigen Gewinne am Ende des Geschäftsjahres übersteigen, müssen

die Gesellschafter diesen Überschuss der Gesellschaft erstatten.

VI. Auflösung - Liquidation

15.1. Die Gesellschaft kann jederzeit durch einen Beschluss der Gesellschafter aufgelöst werden, der von der Hälfte

(50%) der Gesellschafter, welche drei Viertel (75%) des Gesellschaftskapitals halten, gefasst wird. Die Gesellschafter
benennen einen oder mehrere Liquidatoren, die nicht Gesellschafter sein müssen, zur Durchführung der Liquidation und
bestimmen deren Anzahl, Befugnisse und ihre Vergütung. Sofern die Gesellschafter nichts anderes entscheiden, verfügen
die Liquidatoren über die weitest gehenden Befugnisse zur Realisierung der Aktiva und zur Bezahlung der Verbindlich-
keiten der Gesellschaft.

15.2. Der Überschuss nach zur Realisierung der Aktiva und Bezahlung der Verbindlichkeiten wird an die Gesellschafter

proportional zu ihrem Anteil an den jeweils von ihnen gehaltenen Anteilen verteilt.

VII. Allgemeine Bestimmungen

16.1. Benachrichtigungen und Mitteilungen werden erstellt oder abbedungen und Umlaufbeschlüsse des Vorstands

werden jeweils schriftlich dokumentiert durch ein unterzeichnetes Dokument, welches per Post, per Fax, per Email oder
sonstiger elektronischer Kommunikationsmittel zugestellt wird und zu ihrem Nachweis genügt.

16.2. Vollmachten werden auf die oben genannte Art und Weise erteilt. Vollmachten in Verbindung mit Vorstandssi-

tzungen können durch einen Geschäftsführer auch auf andere durch den Vorstand gestatteten Weise erteilt werden.

16.3. Unterschriften dürfen handschriftlich oder elektronisch geleistet werden, sofern sie alle gesetzlichen Erforder-

nisse erfüllen und damit handschriftlichen Unterschriften gleichzustellen sind. Unterschriften unter die Umlaufbeschlüsse
werden auf einem Original oder auf mehreren Ausfertigungen des gleichen Dokuments geleistet, welche zusammen ein
einziges Dokument darstellen.

16.4. Alle Angelegenheiten, die nicht ausdrücklich durch die Satzung geregelt sind, sind im Einklang mit dem Gesetz zu

bestimmen und stehen unter dem Vorbehalt zwingender gesetzlicher Regelungen, die nicht abbedungen werden können,
und unter dem Vorbehalt von Verträgen, welche die Gesellschafter von Zeit zu Zeit miteinander geschlossen haben.“

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2014.

139480

L

U X E M B O U R G

<i>Zeichnung und Zahlung

Life Bond Holding GmbH &amp; Co KG, vertreten wie oben angegeben, zeichnet achtzehntausendfünfhundert (18.500)

Anteile in der Form von registrierten Namensanteilen zu einem Nennwert von je einem US-Dollar (USD 1.-) und erklärt
sich einverstanden, diese durch eine Einlage in bar in Höhe von achtzehntausendfünfhundert US-Dollar (USD 18.500.-)
zu bezahlen.

Dem Notar wurde ein Nachweis darüber übergeben, dass der Betrag von achtzehntausendfünfhundert US-Dollar (USD

18.500.-) der Gesellschaft zur Verfügung steht.

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen jeder Art werden auf

ungefähr EUR 1.300,- geschätzt.

<i>Beschluss der Gesellschafter

Unmittelbar nach Gründung der Gesellschaft beschließt die alleinige Gesellschafterin wie folgt:
1. Die folgenden Personen werden als Geschäftsführer der Gesellschaft bis zur nächsten Gesellschafterversammlung,

welche die Jahresabschlüsse zum 31. Dezember 2014 genehmigt, ernannt:

- Herr Michael Hoesch, geboren am 29.01.1959 in Baden-Baden, Deutschland, mit beruflicher Anschrift in 5, Heienhaff,

L-1736 Senningerberg;

- Herr Dr. Rüdiger Frischmuth, geboren am 08.06.1965 in Witten, Deutschland, mit beruflicher Anschrift in 5, Heien-

haff, L-1736 Senningerberg;

- Herr Mihail Belostennyj, geboren am 10.10.1981 in Kiew, Ukraine, mit beruflicher Anschrift in 5, Heienhaff, L-1736

Senningerberg;

- Herr Ulrich Lewandowski, geboren am 22.05.1957 in Hamburg, Deutschland, mit beruflicher Anschrift in 5, Heienhaff,

L-1736 Senningerberg.

2. Der Sitz der Gesellschaft wird errichtet in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.

<i>Erklärung

Der unterzeichnende Notar, welcher die deutsche Sprache versteht und spricht, bestätigt hiermit, dass auf Anweisung

der oben erschienenen Partei die vorliegende Urkunde in deutscher Sprache gefolgt von einer englischen Version verfasst
ist, und dass auf Anforderung derselben erschienenen Partei im Falle von inhaltlichen Unterschieden zwischen den spra-
chlichen Versionen, die deutsche Version entscheidend sein soll.

WORÜBER Urkunde aufgenommen wurde in Luxemburg, an dem zu Beginn dieser Urkunde genannten Datum.
Nachdem diese Urkunde den Vertreter der erschienenen Partei, welcher dem unterzeichneten Notar durch Name,

Nachname, Familienstand und Anschrift bekannt sind, vorgelesen wurde, hat dieser Vertreter zusammen mit dem Notar
diese Urkunde unterzeichnet.

Es folgt die Englische Übersetzung

In the year two thousand and fourteen, on the twelfth of August.
Before Maître Francis KESSELER, notary, residing in Esch-sur-Alzette,

THERE APPEARED:

Life Bond Holding GmbH &amp; Co KG, a company duly incorporated under the laws of Germany, having its registered

address at Münchner Straße 54, 82069 Hohenschäftlarn and registered with the register court of Munich under number
HRA 88777, represented by Michael G. Hoesch and Ulrich Lewandowski,

here represented by Marcus PETER, lawyer, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power of attorney

given in Hohenschäftlarn on 12 August 2014,

Such power of attorney, after having been signed ne varietur by the representative of the appearing parties and the

undersigned notary, will remain annexed to this deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as above, have requested the undersigned notary, to state as follows the articles of

incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

I. Name - Registered office - Corporate object - Duration

Art. 1. Name. The name of the company is Life Bond Lux S.à.r.l. (the “Company”). The Company is a private limited

liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and, in
particular, the law of August 10, 1915 relating to commercial companies as amended from time to time (the “1915 Law”),
and these articles of incorporation (the “Articles”).

Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in the community of Niederanven (Senningerberg), Grand

Duchy of Luxembourg. It may be transferred within the community of Niederanven by a resolution of manager or the

139481

L

U X E M B O U R G

board of managers of the Company (the “Board”) as the case maybe. The registered office may be transferred to any
other  place  in  the  Grand  Duchy  of  Luxembourg  by  a  resolution  of  the  shareholders,  acting  in  accordance  with  the
conditions prescribed for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a

resolution of the Board. Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events
have occurred or are imminent and that these developments or events may interfere with the normal activities of the
Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the reg-
istered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these circumstances. Such temporary
measures have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered
office, remains a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Corporate object.
3.1. The object of the Company is to act as the managing general partner of Life Bond USA 2.0 SCSp, a company in

the form of a special limited partnership (société en commandite spéciale).

3.2. The Company shall furthermore have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever,

in Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the
transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes, receivables and other securities of any kind
(debt or otherwise), the possession, the administration, the development and the management of its portfolio.

3.3 The Company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial

enterprise.

3.4 The Company may render or receive any assistance by way of loans, guarantees or otherwise to or from any

company belonging to the same group of companies or to or from third parties.

3.5 The Company may subordinate its claims in favour of third parties for the obligations of any such companies or

undertakings.

3.6 In addition it may take any controlling and supervisory measures and carry out any legal, commercial, technical and

financial transaction and any operation whether related to real estate assets or otherwise, which it may deem useful for
the accomplishment and development of its purpose.

Art 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited duration.
4.2. The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy

or any similar event affecting one or several shareholders.

II. Share capital - Shares

Art. 5. Share capital.
5.1. The share capital is set at eighteen thousand five hundred US dollar (USD 18,500.-), represented by eighteen

thousand five hundred (18,500) shares in registered form, having a par value of one US dollar (USD 1.-) each, all subscribed
and fully paid-up.

5.2. The share capital may be increased or decreased in one or several times by a resolution of the shareholders, acting

in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

Art. 6. Shares.
6.1. The shares are indivisible. The Company recognizes only one (1) owner per share. The shares will only be issued

in registered form.

6.2. Shares are freely transferable among shareholders. Where the Company has a sole shareholder, shares are freely

transferable to third parties.

Where the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to

the prior approval of the shareholders representing at least three-quarters of the share capital.

The transfer of shares by reason of death of a shareholder to third parties must be approved by the shareholders

representing three-quarters of the rights owned by the survivors.

A share transfer is only binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the

Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

6.3. A register of shareholders is kept at the registered office and may be examined by each shareholder upon request.
6.4. The Company may redeem its own shares provided that the Company has sufficient distributable reserves for

that purpose or if the redemption results from a reduction of the Company's share capital.

III. Management - Representation

Art. 7. Appointment and Removal of managers.
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which sets

the term of their office.

139482

L

U X E M B O U R G

7.2. The managers may be removed at any time (with or without cause) by a resolution of the shareholders.

Art. 8. Board of managers. If several managers are appointed, they constitute the Board.
8.1 Powers of the Board
(i) All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of

the Board, who has all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the corporate object.

(ii) Special and limited powers may be delegated for specific matters to one or more agents by the Board.
8.2. Procedure
(i) The Board meets upon the request of any manager, at the place indicated in the convening notice which is exclusively

in Luxembourg.

(ii) Written notice of any meeting of the Board is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance by

mail, facsimile, e-mail or any other electronic means of communication, except in case of emergency, the nature and
circumstances of which must be set forth in the notice of the meeting.

(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and if they state to have full knowledge

of the agenda of the meeting. Notice of a meeting may also be waived by a manager, either before, within or after a
meeting. Separate written notices are not required for meetings that are held at times and places indicated in a schedule
previously adopted by the Board.

(iv) A manager may grant a power of attorney to another manager in order to be represented at any meeting of the

Board.

(v) The Board can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented. Resolutions

of the Board are validly taken by a majority of the votes of the managers present or represented. The resolutions of the
Board are recorded in minutes signed by the chairman of the meeting or, if no chairman has been appointed, by all the
managers present or represented.

(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference or by any other means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. The
participation by these means is deemed equivalent to a participation in person at a meeting duly convened and held.

(vii) Circular resolutions signed by all the managers are valid and binding as if passed at a Board meeting duly convened

and held and bear the date of the last signature.

8.3. Representation
(i) The Company is bound towards third parties in all matters by the joint signatures of any two (2) managers.
(ii) The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have

been delegated.

Art. 9. Sole manager.
9.1. If the Company is managed by a sole manager, any reference in the Articles to the Board or the managers is to

be read as a reference to such sole manager, as appropriate.

9.2. The Company is bound towards third parties by the signature of the sole manager.
9.3. The Company is also bound towards third parties by the signature of any person to whom special powers have

been delegated.

Art. 10. Liability of the managers. The managers may not, by reason of their mandate, be held personally liable for any

commitments validly made by them in the name of the Company, provided such commitments comply with the Articles
and the 1915 Law.

IV. Shareholder(s)

Art. 11. General Meeting of Shareholders.
11.1. Decisions of shareholders shall be taken in a general meeting or by written consultation at the instigation of the

Board.

11.2. No decision is deemed validly taken until it has been adopted by the shareholders representing more than half

of the share capital. If this majority is not reached at the first general meeting or first written consultation, the shareholders
are convened by registered letter to a second general meeting or consulted a second time and the resolutions are adopted
at the general meeting by a majority of the vote regardless of the proportion of the share capital represented.

11.3. However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the share-

holders owning at least three quarters of the company’s share capital, subject to the provisions of the 1915 Law.

11.4 Any change in the nationality of the Company and any increase of a shareholder's commitment in the Company

require the unanimous consent of the shareholders.

11.5 A shareholder may grant a written power of attorney to another person, whether or not a shareholder, in order

to be represented at any general meeting

139483

L

U X E M B O U R G

Art. 12. Sole shareholder.
12.1. Where the Company has only one (1) shareholder, the sole shareholder exercises all powers conferred by the

1915 Law to the general meeting.

12.2. Any reference in the Articles to the shareholders and the general meeting is to be read as a reference to such

sole shareholder or the resolutions of the latter, as appropriate.

12.3. The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.

V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision

Art. 13. Financial year and approval of annual accounts.
13.1. The financial year for the Company begins on the first (1 

st

 ) of January and ends on the thirty-first (31 

st

 ) of

December of each year.

13.2. Each year, the Board prepares the balance sheet and the profit and loss account, as well as an inventory indicating

the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarizing the Company's commitments and the debts
of the manager(s) and shareholders towards the Company.

13.3. Each shareholder may inspect the inventory and the balance sheet at the registered office.
13.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual general meeting within six (6) months

from the closing of the financial year.

Art. 14. Allocation of profits.
14.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) is allocated to the reserve required by Law. This

allocation ceases to be required when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share
capital.

14.2. The shareholders determine how the balance of the annual net profits is disposed of. It may allocate such balance

to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward.

14.3. Interim dividends may be distributed, at any time upon decision by the Board, under the following conditions:
(i) interim accounts are drawn up by the Board;
(ii) these interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for

distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last
financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and distrib-
utable reserves, and decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal reserve;

(iii) the decision to distribute interim dividends must be taken by the Board within two (2) months from the date of

the interim accounts;

(iv) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company;

and

(v) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders

must refund the excess to the Company.

VI. Dissolution - Liquidation

15.1. The Company may be dissolved at any time, by a resolution of the shareholders, adopted by one-half (50%) of

the shareholders holding three-quarters (75%) of the share capital. The shareholders appoint one or several liquidators,
who need not be shareholders, to carry out the liquidation and determine their number, powers and remuneration.
Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators have the broadest powers to realize the assets and pay
the liabilities of the Company.

15.2. The surplus after the realization of the assets and the payment of the liabilities is distributed to the shareholders

in proportion to the shares held by each of them.

VII. General provisions

16.1. Notices and communications are made or waived and the managers circular resolutions are evidenced in writing

by a signed document transmitted by mail, facsimile, e-mail or any other means of electronic communication being suffi-
cient proof thereof.

16.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with

Board meetings may also be granted by a manager in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

16.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements to be deemed

equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers Circular Resolutions are affixed on one original or on
several counterparts of the same document, all of which taken together constitute one and the same document.

16.4. All matters not expressly governed by the Articles are determined in accordance with the law and, subject to

any provisions of the law that may not be waived, any agreement entered into by the shareholders from time to time.

139484

L

U X E M B O U R G

<i>Transitory provision

The first financial year begins on the date of this deed and ends on December 31, 2014.

<i>Subscription and payment

Life Bond Holding GmbH &amp; Co KG represented as stated above, subscribes to eighteen thousand five hundred (18,500)

shares in registered form, with a nominal value of one US dollar (USD 1.-) each, and agrees to pay them in full by a
contribution in cash in the amount of eighteen thousand five hundred US dollar (USD 18,500.-).

The amount of eighteen thousand five hundred US dollar (USD 18,500.-) is at the disposal of the Company, evidence

of which has been given to the undersigned notary.

<i>Costs

The expenses, costs, remunerations or charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed, are estimated approximately at EUR 1,300.-

<i>Resolutions of the shareholders

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder of the Company resolved the following:
1. The following persons are appointed as managers of the Company until the next general meeting approving the

annual accounts as at 31 December 2014:

- Mr. Michael Hoesch, born on 29/01/1959 in Baden-Baden, Germany, with professional address in 5, Heienhaff, L-1736

Senningerberg;

- Mr. Rüdiger Frischmuth (Dr.), born on 08/06/1965 in Witten, Germany, with professional address in 5, Heienhaff,

L-1736 Senningerberg;

- Mr. Mihail Belostennyj, born on 10/10/1981 in Kiew, Ukraine, with professional address in 5, Heienhaff, L-1736

Senningerberg;

- Mr. Ulrich Lewandowski, born on 22/05/1957 in Hamburg, Germany, with professional address in 5, Heienhaff, L-1736

Senningerberg.

2. The registered office of the Company is set at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks German, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in German, followed by an English version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the German text, the German version will prevail.

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, known to the notary by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the said proxyholder signed together with the notary the present deed.

Signé: Peter, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette, Actes Civils, le 11 août 2014. Relation EAC / 2014/11019. Reçu: soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2014131936/467.
(140149807) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2014.

Microfinance Enhancement Facility SA, SICAV-SIF, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds

d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 144.746.

In the year two thousand fourteen, on the eighteenth day of July;
Before us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned;

Was held

an extraordinary general meeting (the “Meeting”) of the corporation established in Luxembourg under the denomi-

nation of Microfinance Enhancement Facility SA, SICAV-SIF, a “société anonyme”, having its registered office at 5, rue
Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, incorporated by deed of Me Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg,
enacted on February 5, 2009, published in the “Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations”, number 391 of February
23, 2009, registered with the Luxembourg Trade and Companies Registry under the number B 144746 (the “Fund”),

139485

L

U X E M B O U R G

and whose articles of association have been amended several times and for the last time pursuant to a deed of the

undersigned notary, on 25 October 2013, published in the “Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations”, number
3154, page 151390, of 12 December 2013.

The  Meeting  is  presided  by  Mr.  Georges  BECKENE,  Vice  President,  CREDIT  SUISSE  FUND  SERVICES  (LUXEM-

BOURG) S.A., residing professionally in Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

The chairman appoints as secretary Mrs. Jacqueline SIEBENALLER, Director, CREDIT SUISSE FUND SERVICES (LU-

XEMBOURG) S.A., residing professionally in Luxembourg, 5, rue Jean Monnet and the Meeting elects as scrutineer Mr.
Garrett KILLEEN, Vice President, CREDIT SUISSE FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., residing professionally in
Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

The chairman requests the notary to act that:
I. The agenda of the Meeting is the following:
1. Modification of Title II “Share Capital - Shares - Net Asset Value”
Amendment of Art. 8 “Issue of Shares” in order to allow for the subscription of A and B Shares between Valuation

Dates based on the initial offering price.

2. Modification of Title III “Administration and Supervision”
Amendment of Art. 15 “Directors” in order to comply with the requirements provided by the CSSF in order for the

Fund to be considered as AIFM Law out of scope.

3. Modification of Title IV “General meetings - Accounting Year - Distributions”
Amendment  of  Art.  27  “Payment  waterfall”  in  Section  “Cash  waterfall”  (indent  “Initial  use  of  available  cash”  and

“Satisfaction of the entitlements under the Debt Instruments”) and Section “Liquidation of the Fund” in order to consider
the possibility for the Fund to conclude several revolving credit facilities.

II. The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their

shares are shown on an attendance list. This attendance list, signed ne varietur by the proxyholders of the represented
shareholders, by the bureau of the Meeting and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the
same time with the registration authorities.

III. The present Meeting was convened by notices containing the agenda sent by registered mail on 11 and 25 June

2014 to the registered shareholders.

IV. The resolutions on the agenda require a quorum of 70% of the share capital of the Fund and may only be validly

take if approved by at least 3/4 of the votes cast.

V. It appears from the attendance list that, out of the 4’384.54 shares in issue as at 18 July 2014, 4’087 shares are

present or represented and that they represent 93% of the share capital of the Fund.

VI. As a result of the foregoing, the present Meeting is regularly constituted and may validly deliberate on the items of

the agenda.

After approval of the statements of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the Meeting

passed, after deliberation, the following resolutions:

<i>First resolution

The Meeting approved the amendment of Art. 8 “Issue of Shares” in order to allow for the subscription of A and B

Shares between Valuation Dates based on the initial offering price by replacing the existing wording by the following
wording:

“The board of directors is authorized without limitation to issue in several tranches, an unlimited number of fully paid

up shares at any time without reserving to the existing shareholders a preferential right to subscribe for the shares to be
issued.

The board of directors may impose restrictions on the frequency at which shares shall be issued in any class of shares;

the board of directors may, in particular, decide that shares of any class shall only be issued during one or more offering
periods or at such other periodicity as provided for in the Issue Document of the Fund.

Whenever the Fund offers A Shares for subscription within a tranche after the initial subscription period for such

tranche, the price per share at which such shares are offered shall be based on the initial offering price of the relevant
class(es) and tranch(es) unless the net asset value of all B Shares and C Shares of the relevant tranche as determined in
compliance with Article 13 hereof as of such Valuation Date (as defined hereinafter), is nil in which case such A Shares
are issued on such Valuation Date and subscribed based on their applicable net asset value.

Whenever the Fund offers B Shares for subscription within a tranche after the initial subscription period for such

tranche, the price per share at which such shares are offered shall be based on the initial offering price of the relevant
class(es) and/or tranche(s) unless the net asset value of all C Shares as determined in compliance with Article 13 hereof
as of such Valuation Date (as defined hereafter) is nil, in which case such B Shares are issued on such Valuation Date and
subscribed based on their applicable net asset value.

Whenever the Fund offers C Shares for subscription within a tranche after the initial subscription period for such

tranche, the price per share at which such shares are offered shall be issued on such Valuation Date and subscribed based

139486

L

U X E M B O U R G

on their applicable net asset value as determined in compliance with Article 13 hereof as of such Valuation Date (as
defined hereafter).

Such price may be increased by a percentage estimate of costs and expenses to be incurred by the Fund when investing

the proceeds of the issue and by applicable sales commissions, as approved from time to time by the board of directors.
The price so determined shall be payable within a period as determined from time to time by the board of directors and
disclosed in the Issue Document of the Fund. The board of directors may delegate to any director, manager, officer or
other duly authorized agent the power to accept subscriptions, to receive payment of the price of the new shares to be
issued and to deliver them.”

<i>Second resolution

The Meeting approved the amendment of Art. 15 “Directors” in order to comply with the requirements provided by

the CSSF in order for the Fund to be considered as AIFM Law out of scope by including the following wording between
the first and the second paragraph:

“At least a ¾ majority of the members of the Board shall be representatives of / proposed by (i) supranational insti-

tutions (such as the European Central Bank, the European Investment Bank, the European Financial Stability Facility S.A.,
the European Stability Mechanism, the European Investment Fund, the European Development Finance Institutions and
bilateral development banks, the World Bank, the International Monetary Fund, and other supranational institutions and
similar international organisations); (ii) the Luxembourg Central Bank and other national central banks; and/or (iii) any
national, regional and local governments, and bodies or other organisations or institutions which manage funds supporting
social security and pension systems.”

<i>Third resolution

The Meeting approved the amendment of Art. 27 “Payment waterfall” in Section “Cash waterfall” (indent “Initial use

of available cash” and “Satisfaction of the entitlements under the Debt Instruments”) and Section “Liquidation of the
Fund” in order to consider the possibility for the Fund to conclude several revolving credit facilities, as amended.

The changes approved by the present Meeting will enter into force on 18 July 2014.
Nothing else being on the agenda, and nobody wishing to address the Meeting, the Meeting was closed.

<i>Statement

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English.

WHEREUPON the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present
original deed.

Signé: G. BECKENE, J. SIEBENALLER, G. KILLEEN, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 juillet 2014. LAC/2014/34804. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société;

Luxembourg, le 11 août 2014.

Référence de publication: 2014131967/111.
(140149868) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2014.

E.I.M.A. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4963 Clemency, 9bis, rue Basse.

R.C.S. Luxembourg B 94.192.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 19 août 2014

L'Assemblée Générale a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
- De transférer le siège social de la Société du 9, rue Basse, L-4963 Clémency au 9bis, rue Basse, L-4963 Clémency.
- De ne pas renouveler le mandat de l'administrateur et administrateur-délégué Michel Antolinos.
- En son remplacement, l'assemblée générale décide de nommer Monsieur Grégory Antolinos né le 4 septembre 1970

à Rillieux la Pape FRANCE, domicilié au Rue du Glycines, 6 à CH - 1273 Arzier (Suisse), et, Monsieur Sébastien Castagna,
né le 19 mai 1973 à l'Hay-les-Roses, ayant pour adresse professionnelle, 9bis, rue Basse, L-4963 Clémency. Le mandat
des nouveaux administrateurs viendra à échéance lors l'assemblée générale annuelle de 2020.

139487

L

U X E M B O U R G

- D'accepter la nomination de Monsieur Grégory ANTOLINOS, né le 4 septembre 1970 à Rillieux la Pape FRANCE,

domicilié au Rue du Glycines, 6 à CH - 1273 Arzier (Suisse), à la fonction d'administrateur-délégué. Il pourra représenter
la société vis-à-vis des tiers par sa seule signature. Son mandat s'achèvera lors de l'assemblée générale annuelle de 2020.

- De renouveler le mandat des administrateurs, Field Investment S.A., société anonyme, et, Avera Limited, pour une

durée de six ans prenant fin lors de l'assemblée générale annuelle de 2020.

- De ne pas renouveler le mandat du commissaire aux comptes BDO De Chazal Du Mée.
- En son remplacement, nomination de la société ACCOUNTIS S.A., société anonyme, L-2352 Luxembourg, 4, rue

Jean-Pierre Probst.

Le mandat du nouveau commissaire aux comptes viendra à échéance lors l'assemblée générale annuelle de 2020.
- Conformément aux dispositions de l'article 51bis de la loi du 25 août 2006 sur les sociétés commerciales, l'adminis-

trateur Field Investment S.A., société anonyme, R.C.S. Luxembourg B-168082, 9, rue Basse, L-4963 Luxembourg, a désigné
comme représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour son compte au conseil d'admi-
nistration de la société E.I.M.A. S.A., société anonyme, Monsieur Grégory ANTOLINOS, Rue du Glycines, 6 à CH - 1273
Arzier (Suisse).

Pour extrait conforme

Le 19 août 2014.

Référence de publication: 2014131187/31.
(140149079) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2014.

Degroof PE Fund, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 135.420.

<i>Extrait des résolutions du Conseil d'Administration tenu à Luxembourg le 18 août 2014

Les Administrateurs prennent acte de la démission de Monsieur Marc-André BECHET de sa fonction d'administrateur

de la Société avec effet au 10 juillet 2014.

Les Administrateurs décident de coopter Madame Anne-Marie GOFFINET avec adresse professionnelle au 12, rue

Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg en qualité d'administrateur de la Société, en remplacement de Monsieur Marc-
André BECHET, administrateur démissionnaire, avec effet au 18 août 2014.

Cette nomination est sujette à ratification lors de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires de la

Société.

Luxembourg, le 19 août 2014.

<i>Pour DEGROOF PE FUND
BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent Domiciliataire

Référence de publication: 2014131163/19.
(140149240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2014.

Herblay S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 25.000,00.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 139.916.

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven (Grand-

Duché de Luxembourg), en date du 9 juin 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1837
du 25 juillet 2008.

Les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Herblay S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2014131288/15.
(140148771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2014.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

139488


Document Outline

Alma Jem S.C.I

AL.VE S.A.

Arissa Holding S.A.

Cafe 16 S.A.

Corton Meyney S.A.

Degroof PE Fund

E.I.M.A. S.A.

Gerlach Investments S.à r.l.

Herblay S.à r.l.

Heureko S.A.

Hicof S.à r.l.

International Strategy Corporation S.A.

Intuitip S.A.

IT-LUX software solutions S.A.

Kapa Participations S.A.

Key Concept Constructions S.à r.l.

Kiwi International Corporation S. à r.l.

Knewledge

Kolibri s.à r.l.

La Considération de l'Ange Blanc

Larry II LM S.à r.l.

Larry II Midco S.à r.l.

Larry Topco S.à r.l.

LEAF

League Jinn S.à r.l.

Le Mètre Carré S.à r.l.

Liam Finance S.à r.l.

Life Bond Lux S.à r.l.

LMLux

Lululemon LU Holdings S.à r.l.

Luna S.à r.l.

LuxCo 113 S.à r.l.

LuxCovering

Luxury Design S.C.A.

Mangoo S.à r.l.

Marco Zenner S.à r.l.

Microfinance Enhancement Facility SA, SICAV-SIF

Natex S.A.

Navistar International Luxembourg Sàrl

Navistar Luxembourg Holding S.à r.l.

Nexus Luxembourg S.à r.l.

Nickel Grafton S.à r.l.

Norbert KELLER A.G.

Northam CCPF PropCo BTS (7) S.à r.l.

Northam CCPF PropCo BTS (9) S.à r.l.

Nubia Investment S.A.

OCM Luxembourg Coppice Midco S.à r.l.

Oracle Bucéphale S.à r.l.

Rancho Properties Holdings S.à r.l.

Restaurants Food Management I S.A.

Ribel Finance S.A.

Saint George UCITS SICAV

Samson

SLCO SA

Southern Participations S.A.

Spheretech International S.A.