This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2858
10 octobre 2014
SOMMAIRE
Actimalux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137144
Aerium H2O S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137143
Agenor S.A. SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137143
Ahlers International S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
137148
Alpha Wealth Management Luxembourg
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137139
Apolux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137150
Ares Capital Europe II Holdings S.à r.l. . . .
137139
Arsemia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137148
Arulux First S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137139
Aspen FinanceCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
137140
Attila S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137144
Awas Luxembourg 6220 S.A. . . . . . . . . . . . .
137164
Baluardo Funding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
137151
B & B Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
137149
Becos S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137138
Benaruca S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137138
Best Services S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137147
B&W NE Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
137149
Capitaux d'Investissements et de Résultats
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137147
Centaur Luxco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137141
CEREP Italy One S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
137144
Circeo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137147
Citra S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137148
Clearsight Holdings (Luxembourg) S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137141
CN Air S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137141
ColorPortal Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
137138
DAIWA SBI Lux Funds SICAV . . . . . . . . . .
137139
D'Amici S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137138
Depalom S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137140
Die Heimkinoschmiede S.à r.l. . . . . . . . . . .
137139
Dinavest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137143
ECommerce Holding II S.à r.l. . . . . . . . . . . .
137173
Eralda International, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
137147
European Commodity Company S.A. . . . .
137182
Europrovincial Properties S.à r.l. . . . . . . . .
137142
Evergreen Investments S.A. . . . . . . . . . . . . .
137149
Food Service Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
137143
Highstreet Propco III S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
137151
Immobilière du X septembre S.A. . . . . . . .
137160
IT Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137158
Levanna Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137184
Louis Vuitton Luxembourg S.à r.l. . . . . . . .
137144
Luxe Drive S.L. S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137145
LUXIMMO Achte Beteiligungsgesellschaft
AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137145
Luxroyal Management S.A. . . . . . . . . . . . . .
137142
Magequam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137145
Mandarina Real Estate S.à r.l. . . . . . . . . . . .
137146
Master 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137145
Muirfield Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
137142
Partners Group Global Infrastructure SI-
CAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137146
Savoia S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137140
Tenotel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137138
Te Ora S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137140
UBS (Lux) Sicav 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137146
137137
L
U X E M B O U R G
Tenotel, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 132.086.
Le Bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014128276/10.
(140144709) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2014.
D'Amici S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9160 Ingeldorf, 28, route d'Ettelbruck.
R.C.S. Luxembourg B 161.915.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014128528/10.
(140145933) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2014.
Becos S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 70.467.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2014128450/11.
(140145929) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2014.
Benaruca S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 112.246.
<i>Extrait du Procès-verbal de l'assemblée ordinaire des actionnaires tenue au siège social de la société en date du 7 août 2014i>
<i>Troisième Résolutioni>
Les actionnaires ont approuvés le renouvellement de Monsieur Alberto Morandini en tant qu'administrateur de la
société avec effet immédiat et jusqu'au 7 Novembre 2017.
Référence de publication: 2014128453/11.
(140145887) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2014.
ColorPortal Europe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 143.978.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
août 2014.
Maître Léonie GRETHEN
<i>Notairei>
Référence de publication: 2014128479/12.
(140145688) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2014.
137138
L
U X E M B O U R G
Die Heimkinoschmiede S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6776 Grevenmacher, 7, Op der Ahlkërrech.
R.C.S. Luxembourg B 159.063.
Der Jahresabschluss vom 31.12.2012 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 12.08.2014.
Référence de publication: 2014128533/10.
(140145975) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2014.
DAIWA SBI Lux Funds SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 181.392.
Le Bilan au 31 mars 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
À Luxembourg, le 12 août 2014.
Référence de publication: 2014128536/10.
(140145789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2014.
Ares Capital Europe II Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 175.675.
Statuts coordonnés, suite à l’assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de rési-
dence à Esch/Alzette, en date du 28 janvier 2014 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 28 février 2014.
Référence de publication: 2014128396/11.
(140145992) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2014.
Arulux First S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 167.221.
Statuts coordonnés, suite à l’assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de rési-
dence à Esch/Alzette, en date du 23 janvier 2014 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 24 février 2014.
Référence de publication: 2014128397/11.
(140145747) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2014.
Alpha Wealth Management Luxembourg, Société Anonyme.
Siège social: L-7305 Steinsel, 7, In der Duerrwies.
R.C.S. Luxembourg B 140.354.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 août 2014.
Maître Léonie GRETHEN
<i>Notairei>
Référence de publication: 2014128395/12.
(140146164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2014.
137139
L
U X E M B O U R G
Depalom S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.
Siège social: L-2543 Luxembourg, 34-36, Dernier Sol.
R.C.S. Luxembourg B 132.178.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
L-2543 Luxembourg, le 12 août 2014.
Monsieur Zupanoski Robert.
Référence de publication: 2014128542/10.
(140145580) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2014.
Aspen FinanceCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 1-3, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 161.675.
Statuts coordonnés, suite à l’assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de rési-
dence à Esch/Alzette, en date du 24 janvier 2014 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 24 février 2014.
Référence de publication: 2014128398/11.
(140145358) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2014.
Te Ora S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 140.840.
Par résolutions circulaires signées en date du 30 juillet 2014, le conseil d'administration a décidé de transférer le siège
social de la Société du 26, rue Glesener, L-1630 Luxembourg au 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, avec effet
au 1
er
juillet 2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 août 2014.
Référence de publication: 2014128274/12.
(140145227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2014.
Savoia S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 2.025.300,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 80.031.
Par la présente, il est pris acte que:
- Madame Céline Uvergoels, ayant son adresse professionnelle à 5, rue Guillaume Kroll, L-1882, Luxembourg, a été
nommée gérant de la Société avec effet au 8 août 2014 et, pour une durée indéterminée.
- Monsieur Richard Lund, ayant son adresse professionnelle à 45 Pall Mall, SW1Y 5JG, London, U.K., a été nommé
gérant de la Société avec effet le 8 août 2014 et ce, pour une durée indéterminée.
- Monsieur Paul King, ayant son adresse professionnelle à 28, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, a mis fin à son
mandat de gérant de la Société le 8 août 2014.
- Monsieur Graeme Stening, ayant son adresse professionnelle à 45 Pall Mall, SW1Y 5JG, London, U.K., a mis fin à son
mandat de gérant de la Société le 8 août 2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 8 août 2014.
Gérard Becquer
<i>Géranti>
Référence de publication: 2014128348/21.
(140145101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2014.
137140
L
U X E M B O U R G
CN Air S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1er.
R.C.S. Luxembourg B 122.978.
Le bilan au 31.12.2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
<i>Pour CN AIR SARL
i>Signature
Référence de publication: 2014128516/12.
(140146137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2014.
Clearsight Holdings (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 50.000,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 161.416.
Les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 août 2014.
Malcolm Wilson
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2014128478/13.
(140145379) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2014.
Centaur Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 593.102.980,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 116.538.
Suite à la cession de parts intervenue en date du 11 août 2014 entre Altamar V Private Equity Program 2010 FCR De
Régimen Simplificado, Altamar Secondary Opportunities VII FCR Régimen Simplificado, Altamar Secondary Opportunities
VII BP FCR De Régimen Común, ESP 2008 Conduit LP et Panda LP les parts sociales de la Société, entre ces associés
seulement sont réparties comme suit:
- Panda LP ayant son siège social à PO Box 255, Trafalgar Court, St Peter Port, GY 3QL Guernsey, détient:
8.366.800 parts sociales ordinaires de catégorie X1 d'une valeur nominale de EUR 0,01 chacune.
8.366.800 parts sociales ordinaires de catégorie X2 d'une valeur nominale de EUR 0,01 chacune.
163.326.600 parts sociales préférentielles de catégorie J2A d'une valeur nominale de EUR 0,01 chacune.
1.469.939.800 parts sociales préférentielles de catégorie J2B d'une valeur nominale de EUR 0,01 chacune.
71.334.400 parts sociales préférentielles de catégorie K2A d'une valeur nominale de EUR 0,01 chacune.
642.009.600 parts sociales préférentielles de catégorie K2B d'une valeur nominale de EUR 0,01 chacune.
- Altamar V Private Equity Program 2010 FCR De Régimen Simplificado ne possède plus de part de la Société.
- Altamar Secondary Opportunities VII FCR Régimen Simplificado ne possède plus de part de la Société.
- Altamar Secondary Opportunities VII BP FCR De Régimen Común ne possède plus de part de la Société.
- ESP 2008 Conduit LP ne possède plus de part de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Centaur Luxco S.à r.l.
Jacob Mudde
<i>Géranti>
Référence de publication: 2014128472/27.
(140145457) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2014.
137141
L
U X E M B O U R G
Europrovincial Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 130.000,00.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 119.326.
EXTRAIT
Le 5 août 2014, Canderway Limited, une société régie par le droit des Îles Vierges Britanniques, inscrite au registre
de commerce sous le numéro 1022104 et dont le siège social se situe au Trident Chambers, Wickhams Cay, Road Town,
Tortola, Îles Vierges Britanniques a cédé l'entièreté des parts sociales qu'elle détenait dans la Société, à savoir 5200 parts
sociales à Deutsche Bank Trustee Services (Guernsey) Limited as Trustee of the Card Trust, un trust régi par le droit de
Guernesey, inscrit au registre de commerce de Guernesey sous le numéro 2870 et établi à l'adresse suivante: 523, Lefebvre
Court, Lefebvre Street, St Peter Port, Guernesey GY1 6EJ.
Désormais, Deutsche Bank Trustee Services (Guernsey) Limited as Trustee of the Card Trust est l'associé unique de
la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014130043/17.
(140147256) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2014.
Luxroyal Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 57.636.
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal du Conseil d'Administration tenu le 31 juillet 2014 à 11h30i>
Il résulte dudit procès-verbal que:
Le Conseil d'Administration décide de nommer Mr. Fabio Mastrosimone, né le 13 février 1978 à Rome, Italie, avec
l'adresse professionnelle au 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, en tant que Président du Conseil d'Ad-
ministration de la société.
Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'an 2020.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 juillet 2014.
<i>Pour Luxroyal Management S.A.
i>Fabio Mastrosimone
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2014129582/18.
(140146523) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2014.
Muirfield Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 31.250,00.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 120.642.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions écrites prises par les actionnaires de la Société en date du 12 août 2014 que:
- La démission de M. Luc GERONDAL et M. Olivier LIEGEOIS, gérants de la Société, en date du 12 août 2014, a été
acceptée;
- Ont été nommés en tant que gérant de la Société, avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée:
(i) Mrs. Christelle MATHIEU, née à Virton (Belgique), le 1
er
mars 1978 demeurant professionnellement au 16 avenue
Pasteur L-2310 Luxembourg; et
(ii) P.A.L Management Services S.à.r.l, société de droit luxembourgeois, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés sous le numéro B145164 et ayant son siège social au 16 avenue Pasteur L-2310 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 août 2014.
Référence de publication: 2014129608/19.
(140147064) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2014.
137142
L
U X E M B O U R G
Aerium H2O S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 115.265.
Le bilan au 31 Décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014128407/9.
(140145295) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2014.
Dinavest, Société Anonyme.
Siège social: L-1616 Luxembourg, 28-32, place de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 141.346.
Le rapport annuel au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014128546/10.
(140145501) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2014.
Agenor S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.
R.C.S. Luxembourg B 30.010.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 août 2014.
<i>Pour compte de Agenor S.A. SPF
i>Fiduplan S.A.
Référence de publication: 2014128410/12.
(140145968) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2014.
Food Service Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 80.990.
<i>Extrait de l'assemblée générale des actionnaires du 7 juillet 2014i>
Il résulte des résolutions prises par l'assemblée générale des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 7 juillet 2014
que:
1. Le mandat des administrateurs suivants a été renouvelé jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra
en 2015 approuvant les comptes annuels au 31 décembre 2014:
- Mme Emanuela Brero, employée privée, née à Bra (Italie) le 25 mai 1970, ayant son adresse professionnelle au 20,
avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg;
- M. Stefan Oostvogels, employé privé, né à Bruxelles (Belgique) le 21 Avril 1962, ayant son adresse professionnelle
au 291, route d'Arlon, L-2016 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg;
- Mme Delphine Tempé, employée privée, née à Strasbourg (France) le 15 Février 1971, ayant son adresse profes-
sionnelle au 291, route d’Arlon, L-2016 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.
2. Le mandat de Deloitte Audit ayant son siège social à 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg agissant en tant que
réviseur d'entreprises agréé de la société a été renouvelé jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en
2015 approuvant les comptes annuels au 31 décembre 2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Value Partners S.A.
Référence de publication: 2014130083/23.
(140147090) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2014.
137143
L
U X E M B O U R G
Attila S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1527 Luxembourg, 43, rue Maréchal Foch.
R.C.S. Luxembourg B 75.300.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014128424/9.
(140145962) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2014.
Actimalux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9560 Wiltz, 58, rue du Dix Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 149.433.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fiduciaire ARBO S.A.
Signature
Référence de publication: 2014128406/11.
(140145641) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2014.
Louis Vuitton Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 300.000,00.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 2, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 150.549.
Il résulte des résolutions de l'associé unique de la Société prises en date du 1
er
août 2014, que le mandat de Deloitte
Audit, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B67895 et ayant son siège social au 560, Rue de Neudorf, L - 2220 Luxembourg,
a été prolongé jusqu'à l'assemblée générale des associés qui statuera sur l'approbation des comptes annuels se clôturant
au 31 décembre 2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Louis Vuitton Luxembourg S.à r.l.i>
Référence de publication: 2014128783/14.
(140145361) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2014.
CEREP Italy One S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 92.166.
EXTRAIT
Par résolutions prises en date du 29 juillet 2014, l'associé unique de la Société a décidé:
- d'accepter la démission de M. Robert Konigsberg, ayant son adresse professionnelle au 1001, Pennsylvania Avenue
NW, Suite 220 South, Washington DC 20004-2505, Etats-Unis d'Amérique, de son poste de gérant de la Société avec
effet immédiat; et
- de nommer M. Matthew Lo Russo, directeur, né le 27 janvier 1968 à Stanford, Connecticut, Etats-Unis d'Amérique,
ayant son adresse professionnelle au Lansdowne House, 57 Berkeley Square, W1J 6ER Londres, Royaume-Uni, en tant
que gérant de la Société avec effet immédiat et ce, pour une durée indéterminée.
En conséquence, le conseil de gérance de la Société est, au 29 juillet 2014, constitué de:
- M. Matthew Lo Russo
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 août 2014.
Référence de publication: 2014128506/20.
(140145543) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2014.
137144
L
U X E M B O U R G
LUXIMMO Achte Beteiligungsgesellschaft AG, Société Anonyme.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 82.300.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014128787/9.
(140145628) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2014.
Luxe Drive S.L. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3222 Bettembourg, 35A, route de Dudelange.
R.C.S. Luxembourg B 181.136.
Les comptes annuels au 31-12-2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la gérance
i>Signature
Référence de publication: 2014128786/11.
(140146049) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2014.
Master 6, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 2.382.800,00.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 8, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 162.797.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12.08.2014.
<i>Pour MASTER 6 SARL
i>Société à responsabilité limitée
Référence de publication: 2014128801/12.
(140145512) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2014.
Magequam, Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 174.531.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 4 août 2014i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
annuels au 31 décembre 2019:
<i>ADMINISTRATEUR DE CATEGORIE Ai>
- Monsieur Gilles RIGAL, directeur de sociétés, demeurant au 9, rue Talma, F-75016 Paris, Président;
<i>ADMINISTRATEUR DE CATEGORIE Bi>
- Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques, demeurant professionnellement au 2, avenue
Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg;
- Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de
Gaulle, L-1653 Luxembourg.
Est nommée commissaire aux comptes pour une durée de un an, son mandat expirant lors de l'assemblée générale
ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2019:
- AUDIEX S.A., société anonyme, 9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 4 août 2014.
Référence de publication: 2014128806/22.
(140145963) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2014.
137145
L
U X E M B O U R G
Mandarina Real Estate S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 104.748.
EXTRAIT
Le gérant de la société a décidé de transférer avec effet immédiat le siège social de la société du 11 A, boulevard Joseph
II à L-1840 Luxembourg au 18, rue Robert Stümper à L-2557 Luxembourg.
L'adresse postale de la société est B.P. 282 à L-2012 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 11 août 2014.
Pour extrait conforme
<i>Pour la Société
i>Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2014128808/17.
(140145394) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2014.
UBS (Lux) Sicav 2, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 109.504.
Est élu au Conseil d'Administration avec effet au 19 juin 2014
- M. Kai Gammelin, membre du conseil d'administration Stockerstrasse 64, CH-8002 Zurich pour une période se
terminant à l'assemblée générale annuelle de 2015.
Mandat non renouvelé avec effet au 19 juin 2014
- M. Aloyse Hemmen
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 05 août 2014.
<i>Pour UBS (Lux) SICAV 2
i>UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Mathias Welter / André Guillaume
<i>Associate Director / Directori>
Référence de publication: 2014129818/18.
(140146380) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2014.
Partners Group Global Infrastructure SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 2, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 167.146.
<i>Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre vom 15. Mai 2014i>
Am 15. Mai 2014 kamen am Gesellschaftssitz die Aktionäre obiger Gesellschaft zusammen.
Nach Feststellung der Rechtsgültigkeit, werden folgende Beschlüsse einstimmig gefasst:
Die Verwaltungsratsmandate der Mitglieder Herr Daniel Van Hove, Herr Roland Roffler und Herr Sergio Raposo
werden für ein weiteres Jahr verlängert und enden mit der im Jahr 2015 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung
der Aktionäre.
Das Mandat des Wirtschaftsprüfers PricewaterhouseCoopers Société coopérative (vormais PricewaterhouseCoopers
S.à r.l.) wird um ein Jahr und damit bis zum Ablauf der im Jahr 2015 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der
Aktionäre verlängert.
Luxemburg, den 23. Juli 2014.
WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Unterschriften
Référence de publication: 2014128852/19.
(140145732) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2014.
137146
L
U X E M B O U R G
Best Services S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5550 Remich, 22, rue de Macher.
R.C.S. Luxembourg B 169.543.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014128454/9.
(140145477) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2014.
Eralda International, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9905 Troisvierges, 97, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 96.270.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014128578/10.
(140146061) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2014.
Circeo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3739 Rumelange, 29, rue des Martyrs.
R.C.S. Luxembourg B 185.717.
Les statuts coordonnés au 30/07/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Redange-sur-Attert, le 11/08/2014.
Me Cosita Delvaux
<i>Notairei>
Référence de publication: 2014128514/12.
(140145362) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2014.
Capitaux d'Investissements et de Résultats S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 90.710.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 11 août 2014:i>
Après en avoir délibéré, l'Assemblée Générale renomme:
- Monsieur Henri REITER, avec adresse professionnelle au 40, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux fonctions
d'administrateur;
- Monsieur Jacques RECKINGER, avec adresse professionnelle au 40, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux
fonctions d'administrateur;
- Monsieur Maurice GIRAUD, avec adresse professionnelle au 11, rue des Pommiers, 1295 Mies, aux fonctions d'ad-
ministrateur.
Leurs mandats respectifs prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 dé-
cembre 2019.
L'Assemblée Générale renomme comme commissaire aux comptes:
- FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG, société anonyme, 38, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2019.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Référence de publication: 2014128493/23.
(140145617) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2014.
137147
L
U X E M B O U R G
Arsemia, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 152.494.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour le Conseil d’administrationi>
Référence de publication: 2014129122/10.
(140146952) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2014.
Ahlers International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 30.499.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 25 avril 2014i>
<i>Conseil d'Administrationi>
L'assemblée générale a décidé de nommer comme nouvel administrateur de la société pour la durée d'un an, son
mandat venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2015, Monsieur De COSTER Johan, demeurant à
191 Oudeheerweg-Ruiter, B-9250 Waasmunster.
Pour extrait sincère et conforme
Fons MANGEN
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2014129133/15.
(140147001) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2014.
Citra S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 3.100.000,00.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 208, Val des Bons-Malades.
R.C.S. Luxembourg B 79.127.
EXTRAIT
En vertu d'un acte sous seing privé daté du 23 juillet 2014, Stichting Cornet, une fondation de droit néerlandais, ayant
son siège social à 483 Herengracht 1017 BT Amsterdam, Pays-Bas; a cédé l'intégralité de ses 499,997 parts sociales dans
le capital de la Société avec effet immédiat, respectivement comme suit:
176,549 parts sociales à PRIM Investment 2 S.à r.l., une société à responsabilité limitée (limited liability company) de
droit luxembourgeois, ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Luxembourg, imma-
triculée au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B135.102;
176,399 parts sociales à CRANBERRY Investment S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit Luxembourgeois,
ayant son adresse au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Luxembourg, immatriculée au Registre de Com-
merce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B73.307;
147,049 parts sociales à STRAWBERRY Investment S.à r.l.; une société à responsabilité limitée de droit Luxembour-
geois, ayant son adresse au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Luxembourg, immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B73.314.
L'actionnariat de la société se compose donc désormais comme suit:
PRIM Investment 2 S.à r.l.: 176,550 parts sociales
CRANBERRY Investment S.à r.l.: 176,400 parts sociales
STRAWBERRY Investment S.à r.l.: 147,050 parts sociales
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
CITRA Sàrl
Kuy Ly ANG
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2014128515/29.
(140145386) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2014.
137148
L
U X E M B O U R G
B & B Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 3, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 93.538.
Société anonyme constituée suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 05
mai 2003, publié au Mémorial C numéro 634 du 11 juin 2003 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu
par Maître Jean SECKLER en date du 12 novembre 2008, publié au Mémorial C numéro 239 du 04 février 2009
Les comptes annuels de la société au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014129161/13.
(140146238) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2014.
Evergreen Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 6, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 172.635.
Mit Wirkung zum 1. August 2014 wurde der Sitz der Gesellschaft an folgende Adresse verlegt:
6, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxemburg.
Mit Wirkung zum 1. August 2014 wurde der Geschäftssitz des Verwaltungsratsmitgliedes Silvan Trachsler ebenfalls an
die zuvor genannte Adresse verlegt.
Luxemburg, den 13. August 2014.
Für die Richtigkeit namens der Gesellschaft
<i>Ein Bevollmächtigteri>
Référence de publication: 2014129333/14.
(140146776) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2014.
B&W NE Luxembourg, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 75.000,00.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 169.624.
<i>Extrait de la résolution de l'associé unique de la Société en date du 6 août 2014i>
En date du 6 août 2014, l’associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
D’accepter la démission de:
- Monsieur Philippe Salpetier, en tant que gérant de type B de la Société, avec effet au 6 août 2014; et
- Monsieur Patrick Moinet, en tant que gérant de type B de la Société, avec effet au 6 août 2014.
De nommer les personnes suivantes en tant que gérants de type B de la Société:
- Monsieur Andrej Grossmann, né le 19 décembre 1975 à Berlin, Allemagne, résidant professionnellement à l’Atrium
Business Park, 33 rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, avec effet au 6 août 2014 et
pour une durée indéterminée; et
- Monsieur Philippe van den Avenne, né le 29 avril 1972 à Beloeil, Belgique, résidant professionnellement à l’Atrium
Business Park, 33 rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, avec effet au 6 août 2014 et
pour une durée indéterminée.
Depuis le 6 août 2014, le conseil de gérance de la Société se compose des personnes suivantes:
Monsieur David S. Black, gérant de type A
Monsieur Andrej Grossmann, gérant de type B
Monsieur Philippe van den Avenne, gérant de type B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 août 2014.
Babcock & Wilcox Nuclear Energy, Inc.
Référence de publication: 2014129163/27.
(140146996) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2014.
137149
L
U X E M B O U R G
Apolux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 125.842.
L'an deux mille quatorze, le vingt-quatrième jour du mois de juillet;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné;
S’est réunie
l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme APOLUX S.A. (la «Société»), une société
anonyme ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg, à la section B sous le numéro 125842, constituée le 13 mars 2007 suivant
un acte reçu par Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1049 du 4 juin 2007.
Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu le 22 mars 2013 suivant un acte reçu
par ledit notaire Gérard LECUIT, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1388 du 12 juin
2013.
L'assemblée générale est ouverte sous la présidence de Monsieur Luc HANSEN, licencié en administration des affaires,
demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.
Le président nomme comme secrétaire Madame Carine GRUNDHEBER, licenciée en lettres modernes, demeurant
professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Jacqueline HONYMUS, expert-comptable, demeurant professionnel-
lement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.
Le bureau de l’assemblée ayant ainsi été constitué, le président déclare et requiert le notaire d'acter que:
I) L'ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Augmentation de capital à hauteur de EUR 134.946,65 pour le porter de EUR 2.200.000 à EUR 2.334.946,65 par la
création et l’émission de 824.400 nouvelles actions sans désignation de valeur nominale, bénéficiant des mêmes droits et
avantages que les actions existantes.
2. Souscription et libération des nouvelles actions.
3. Modification subséquente du 1
er
alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 2.334.946,65 (deux millions trois cent trente-quatre mille neuf cent quarante-
six euros et soixante-cinq cents) représenté par 14.264.378 (quatorze millions deux cent soixante-quatre mille trois cent
soixante-dix-huit) actions sans désignation de valeur nominale.»
II) Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions
détenues par les actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et
les mandataires des actionnaires représentés, par les membres du bureau de l’assemblée et le notaire instrumentaire,
restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instru-
mentaire, resteront aussi annexées au présent acte.
III) Il résulte de ladite liste de présence que l’intégralité du capital social est présente ou dûment représentée à la
présente assemblée générale extraordinaire.
IV) Le président constate que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur
tous les points portés à l’ordre du jour.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’Assemblée cette dernière prend à l’unanimité des voix les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social de la Société à concurrence de EUR 134.946,65 (cent trente-
quatre mille neuf cent quarante-six euros et soixante-cinq cents) pour le porter de EUR 2.200.000 (deux millions deux
cent mille euros) à EUR 2.334.946,65 (deux millions trois cent trente-quatre mille neuf cent quarante-six euros et soixan-
te-cinq cents) par la création et l’émission de 824.400 (huit cent vingt-quatre mille quatre cents) nouvelles actions sans
désignation de valeur nominale, bénéficiant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.
<i>Seconde résolutioni>
L’assemblée générale prend acte de et accepte la souscription, par tous les actionnaires et par un nouvel actionnaire,
des nouvelles actions émises, conformément aux procurations dont mention ci-avant, ainsi que la libération des actions
en espèces, de sorte que la somme de EUR 134.946,65 (cent trente-quatre mille neuf cent quarante-six euros et soixante-
cinq cents) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, preuve en ayant été donnée au notaire instrumentant.
137150
L
U X E M B O U R G
<i>Troisième résolutioni>
Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée générale décide de modifier le 1
er
alinéa de l’article 5 des statuts
pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
« Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 2.334.946,65 (deux millions trois cent trente-quatre mille neuf cent quarante-
six euros et soixante-cinq cents) représenté par 14.264.378 (quatorze millions deux cent soixante-quatre mille trois cent
soixante-dix-huit) actions sans désignation de valeur nominale.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée a été clôturée.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société en raison du
présent acte sont évalués à environ mille six cents euros (EUR 1.600,-).
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leur nom, prénom usuel, état
et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: L. HANSEN, C. GRUNDHEBER, J. HONYMUS, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 juillet 2014. LAC/2014/35788. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): Irène Thill.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Luxembourg, le 12 août 2014.
Référence de publication: 2014130455/76.
(140148183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2014.
Baluardo Funding S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 132.212.
Les comptes annuels audités de la société au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2014128440/12.
(140145505) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2014.
Highstreet Propco III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 189.489.
STATUTES
In the year two thousand fourteen, on the eleven day of August.
Before, Maître Martine DECKER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, acting in replacement
of Maître Edouard DELOSCH, notary residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg, which last will remain the
depositary of the present deed,
THERE APPEARED:
Corestate HIGHSTREET HoldCo S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg, having a share capital of EUR 100,000 (one hundred thousand Euro), with registered office at L-2163
Luxemburg, 35, avenue Monterey, Grand Duchy of Luxembourg, and in the process of registration with the Luxembourg
Register of Commerce and Companies,
here represented by Mr Patrick Chantrain, avocat à la Cour, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a
power of attorney, given in Luxembourg on 8 August 2014.
Said proxy, after having been initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and by the undersigned
notary, shall remain attached to the present deed, and be submitted with this deed to the registration authorities.
Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the
articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated.
137151
L
U X E M B O U R G
Art. 1. Name. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) by the name of "HIGHS-
TREET PropCo III S.à r.l." (the Company).
Art. 2. Corporate object. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in
Luxembourg and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any
other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration,
control and development of its portfolio.
In addition, the Company may acquire and sell real estate properties, for its own account, either in the Grand Duchy
of Luxembourg or abroad and it may carry out all operations relating to real estate properties, including the direct or
indirect holding of participations in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition,
development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or
indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-
ment of these purposes.
Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. Registered office. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution
of the manager/board of managers of the Company.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 5. Share capital. The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 35,000.- (thirty-five thousand Euro),
represented by 35,000 (thirty-five thousand) shares having a par value of EUR 1(one Euro) per share.
Art. 6. Amendments to the share capital. The share capital may be changed at any time by a decision of the sole
shareholder or by decision of the shareholder meeting, in accordance with article 15 of these articles of association.
Art. 7. Profit sharing. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct
proportion to the number of shares in existence.
Art. 8. Indivisible shares. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, and only one owner is admitted
per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 9. Transfer of shares. In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely
transferable.
In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorized by the general
meeting of the shareholders who represent at least three-quarters of the paid-in capital of the Company. No such au-
thorization is required for a transfer of shares among the shareholders.
The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-
quarters of the rights belonging to the surviving shareholders.
The requirements of articles 189 and 190 of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as
amended (the Companies Act) will apply.
Art. 10. Redemption of shares. The Company shall have power to acquire shares in its own capital provided that the
Company has sufficient distributable reserves or funds to that effect.
The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of
a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the sole shareholder or the general meeting of
the shareholders. The quorum and majority requirements applicable for amendments to the articles of association shall
apply in accordance with article 15 of these articles of association.
Art. 11. Death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the shareholders. The death, suspension of civil
rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders will not terminate the Company.
Art. 12. Management. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed,
they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed,
revoked and replaced by a decision of the general meeting of the shareholders, adopted by shareholders owning more
than half of the share capital.
The general meeting of the shareholders may at any time and ad nutum (without cause) dismiss and replace the manager
or, in case of plurality, any one of them.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in all circumstances in the name and on behalf
of the Company and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided
the terms of this article 12 have been complied with.
137152
L
U X E M B O U R G
All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of the share-
holders fall within the power of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its sole manager, and, in the case of plurality of managers, by the
sole signature of any member of the board of managers.
The manager, or in case of plurality of managers, any manager may subdelegate his powers for specific tasks to one
or several ad hoc agents. The manager, or in case of plurality of managers, the delegating manager will determine this
agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant
conditions of his agency.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented. The board of managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its
members are present or represented at a meeting of the board of managers.
A chairman pro tempore of the board of managers may be appointed by the board of managers for each board meeting
of the Company. The chairman, if one is appointed, will preside at the meeting of the board of managers for which he
has been appointed. The board of managers will appoint a chairman pro tempore, if one is appointed, by vote of the
majority of the managers present or represented at the board meeting.
In the case of plurality of managers, written notice of any meeting of the board of managers will be given to all managers,
in writing or by telefax or electronic mail (e-mail), at least 24 (twenty-four) hours in advance of the hour set for such
meeting, except in circumstances of emergency. A meeting of the board of managers can be convened by any manager.
This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they state that they have been informed
on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places
prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.
A manager may act at a meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax or electronic mail (e-
mail) another manager as his proxy. A manager may also participate in a meeting of the board of managers by conference
call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting
to be identified and to deliberate. The participation by a manager in a meeting by conference call, videoconference or by
other similar means of communication mentioned above shall be deemed to be a participation in person at such meeting
and the meeting shall be deemed to be held at the registered office of the Company. The decisions of the board of
managers will be recorded in minutes to be held at the registered office of the Company and to be signed by any managers
attending the board meeting, or by the chairman of the board of managers, if one has been appointed. Proxies, if any, will
remain attached to the minutes of the relevant meeting.
Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing in which case the
minutes shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager. The
date of such circular resolutions shall be the date of the last signature. A meeting of the board of managers held by way
of such circular resolutions is deemed to be held in Luxembourg.
Art. 13. Liability of the manager(s). The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their
position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.
Art. 14. General meetings of the shareholders. An annual general meeting of the shareholder(s) shall be held at the
registered office of the Company, or at such other place in the municipality of its registered office as may be specified in
the notice of meeting.
Other general meetings of the shareholder(s) may be held at such place and time as may be specified in the respective
notices of meeting.
As long as the Company has no more than twenty-five (25) shareholders, resolutions of shareholder(s) can, instead
of being passed at general meetings, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be
sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall vote in writing (such vote to be evidenced by letter or
telefax or electronic mail (e-mail) transmission).
Art. 15. Shareholders' voting rights, quorum and majority. The sole shareholder assumes all powers conferred to the
general meeting of the shareholders.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number
of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions
are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority in
number of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital and the nationality of the
Company can only be changed by unanimous vote, subject to the provisions of the Companies Act.
Art. 16. Financial year. The Company's year starts on the 1 January and ends on 31 December of each year.
Art. 17. Financial statements. Each year, with reference to 31
st
December, the Company's accounts are established
and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication
of the value of the Company's assets and liabilities.
137153
L
U X E M B O U R G
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 18. Appropriation of profits, reserves. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after
deduction of general expenses, amortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent
(5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent
(10%) of the Company's nominal share capital. The general meeting shall determine how the remainder of the annual net
profits will be disposed of. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay
interim dividends.
Art. 19. Liquidation. At the time of winding up of the Company the liquidation will be carried out by one or several
liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
Art. 20. Statutory auditor - External auditor. In accordance with article 200 of the Companies Act, the Company needs
only to be audited by a statutory auditor if it has more than 25 (twenty-five) shareholders. An approved independent
auditor (réviseur d'entreprises agréé) needs to be appointed whenever the exemption provided by article 69 (2) of the
Luxembourg act dated 19 December 2002 on the trade and companies register and on the accounting and financial
accounts of companies, as amended does not apply.
Art. 21. Reference to legal provisions. Reference is made to the provisions of the Companies Act for all matters for
which no specific provision is made in these articles of association.
<i>Subscription and Paymenti>
All shares have been subscribed as follows:
Corestate HIGHSTREET HoldCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,000 (thirty-five thousand) shares
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,000 (thirty-five thousand) shares
All shares have been fully paid-up by contribution in cash, so that the sum of EUR 35,000.- (thirty-five thousand Euro)
is at the free disposal of the Company; evidence of which has been given to the undersigned notary.
<i>Transitory Provisionsi>
The first financial year shall begin today and it shall end on 31 December 2014.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately one thousand two hundred Euro (EUR 1,200.)
<i>Extraordinary General Meetingi>
Immediately after the incorporation, the sole shareholder representing the entire subscribed capital of the Company
has herewith adopted the following resolutions:
1. the number of managers is set at 1 (one). The sole shareholder appoints as sole manager of the Company for an
unlimited period of time:
Matthias Sprenker, born on 21 February 1954 in Mülheim an der Ruhr (Germany), with professional address at L-2163
Luxemburg, 35, avenue Monterey; and
2. the registered office is established at L-2163 Luxemburg, 35, avenue Monterey.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a German version; at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the German text, the English version will be prevailing.
Whereof, the present notarial deed is drawn in Hesperange-Howald, on the date stated above, in witness whereof,
the undersigned notary, has signed on the date and year first hereabove mentioned.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party
signed together with, the notary, the present original deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:
Im Jahre zweitausendvierzehn, am elften Tag des Monats August.
Vor Maître Martine DECKER, Notar mit Amtswohnsitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, welcher Maître
Edouard DELOSCH, Notar mit Amtswohnsitz in Diekirch, Großherzogtum Luxemburg in dessen Abwesenheit vertritt,
welch letztgenannter der Bewahrer der vorliegenden Urkunde bleiben wird.
IST ERSCHIENEN:
Corestate HIGHSTREET HoldCo S.à r.l., eine société à responsabilité limitée luxemburgischen Rechts, dessen Ge-
sellschaftskapital EUR 100.000,- (einhunderttausend Euro) beträgt, mit Gesellschaftssitz in L-2163 Luxemburg, 35, avenue
Monterey, Großherzogtum Luxemburg, und in der Registrierungsprozedur beim Luxemburger Handels- und Gesell-
schaftsregister,
137154
L
U X E M B O U R G
vertreten durch Herrn Patrick Chantrain, avocat à la Cour, mit Berufsanschrift in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht
unter Privatschrift, ausgestellt in Luxemburg, am 8. August 2014.
Die Vollmacht wird, nach Unterzeichnung ne varietur durch den Vertreter der Erschienenen und den unterzeichneten
Notar dieser Urkunde als Anlage beigefügt und zusammen mit dieser zur Eintragung eingereicht.
In ihrer oben angegebenen Eigenschaft ersucht die Erschienene den unterzeichneten Notar, die Satzung der Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung, die sie hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden.
Art. 1. Name. Es besteht hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) unter
der Bezeichnung „HIGHSTREET PropCo III S.à r.l.“ (die Gesellschaft).
Art. 2. Gesellschaftszweck. Zweck der Gesellschaft ist, Beteiligungen an luxemburgischen oder ausländischen Gesell-
schaften in welcher Form auch immer und alle anderen Arten von Investitionen vorzunehmen im Wege des Erwerbs oder
der Veräußerung von Wertpapieren durch Kauf oder Verkauf, Tausch oder durch Zeichnung oder in jeder anderen Art
und Weise, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung ihres Portfolios.
Die Gesellschaft darf außerdem auf eigene Rechnung in Luxemburg und im Ausland Immobilien erwerben und veräu-
ßern, und sie darf alle Aktivitäten, die im Zusammenhang mit Immobiliengeschäften stehen, ausführen, unter anderem
direkte oder indirekte Beteiligungen an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften halten, deren Hauptzweck der
Erwerb und die Veräußerung, aber auch die Verwaltung, Vermietung von Immobilien und die Durchführung von Baupro-
jekten ist.
Die Gesellschaft darf Kredite an Gesellschaften vergeben, an denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält,
sowie an Gesellschaften, die derselben Unternehmensgruppe angehören, oder diese Gesellschaften in einer anderen Art
und Weise unterstützen.
Die Gesellschaft darf alle Aktivitäten kommerzieller, industrieller und finanzieller Natur ausführen, die direkt oder
indirekt in Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehen oder den Gesellschaftszweck fördern.
Art. 3. Dauer. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet.
Art. 4. Sitz der Gesellschaft. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Durch einfachen Beschluss der Gesellschafterversammlung kann der Sitz an jeden anderen Ort im Großherzogtum
Luxemburg verlegt werden. Er kann innerhalb der Gemeinde durch einfachen Beschluss des Geschäftsführers oder des
Geschäftsführerrats verlegt werden.
Die Gesellschaft kann Büros und Zweigniederlassungen im Inland und Ausland errichten und unterhalten.
Art. 5. Kapital der Gesellschaft. Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 35.000 (fünfunddreizigtausend Euro), eingeteilt
in 35.000 (fünfunddreizigtausend) Anteile mit einem Nennwert von je EUR 1,- (ein Euro) pro Anteil.
Art. 6. Änderungen des Gesellschaftskapitals. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit gemäß Artikel 15 dieser Satzung
durch einen Beschluss des Alleingesellschafters oder der Gesellschafterversammlung geändert werden.
Art. 7. Gewinnbeteiligung. Jedem Anteil entspricht ein im Verhältnis zu der Gesamtzahl der Anteile stehendes Anrecht
auf die Aktiva und die Gewinne der Gesellschaft.
Art. 8. Unteilbarkeit der Anteile. Gegenüber der Gesellschaft sind einzelne Anteile unteilbar; pro Anteil erkennt die
Gesellschaft nur einen Inhaber an. Mitinhaber müssen gegenüber der Gesellschaft eine einzige Person als ihren Vertreter
benennen.
Art. 9. Übertragung von Gesellschaftsanteilen. Anteile eines Alleingesellschafters sind frei übertragbar.
Bei mehreren Gesellschaftern kann die Übertragung von Anteilen auf Dritte im Wege eines Rechtsgeschäfts unter
Lebenden nur mit Genehmigung durch die Gesellschafterversammlung erfolgen, wobei für eine solche Genehmigung eine
Mehrheit nach Stimmen erreicht werden muss, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten. Für die
Übertragung von Anteilen unter Gesellschaftern der Gesellschaft bedarf es einer solchen Genehmigung nicht.
Die Übertragung der Anteile an Dritte im Falle des Todes eines Gesellschafters bedarf der Zustimmung von mindestens
drei Vierteln der überlebenden Gesellschafter.
In jedem Fall müssen die Bestimmungen der Artikel 189 und 190 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915
über die Handelsgesellschaften (Gesetz von 1915) eingehalten werden.
Art. 10. Rückkauf von Anteilen. Die Gesellschaft ist ermächtigt, Anteile an ihrem eigenen Gesellschaftskapital zu kaufen,
soweit sie über genügend verfügbare Reserven verfügt.
Die Gesellschaft kann Anteile an ihrem eigenen Gesellschaftskapital nur auf Grund eines entsprechenden Beschlusses
durch die Gesellschafterversammlung bzw. durch einen entsprechenden Alleingesellschafterbeschluss zu den in dem zum
Eigenanteilserwerb ermächtigenden Beschluss festgelegten Bedingungen erwerben oder veräußern. Derartige Beschlüsse
unterliegen hinsichtlich der Beschlussfähigkeit und der erforderlichen Mehrheit den in Artikel 15 der Satzung niederge-
legten Voraussetzungen einer Satzungsänderung.
137155
L
U X E M B O U R G
Art. 11. Tod, Aberkennung der bürgerlichen Rechte, Zahlungsunfähigkeit oder Konkurs der Gesellschafter. Das Be-
stehen der Gesellschaft bleibt unberührt vom Tode, der Aberkennung der bürgerlichen Rechte, der Zahlungsunfähigkeit
oder dem Konkurs eines Gesellschafters. Dies gilt auch im Falle eines Alleingesellschafters.
Art. 12. Geschäftsführung. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Wenn mehrere Geschäftsführer
bestellt werden, bilden sie einen Geschäftsführerrat. Der (die) Geschäftsführer muss (müssen) kein(e) Gesellschafter sein.
Der (die) Geschäftsführer wird (werden) durch die Gesellschafterversammlung ernannt, abberufen und ersetzt, wobei
eine Mehrheit nach Stimmen erreicht werden muss, die mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertritt.
Die Gesellschafterversammlung kann jederzeit den Geschäftsführer, oder wenn mehrere Geschäftsführer bestellt
wurden, jeden von ihnen ad nutum (ohne Angabe von Gründen) abberufen und ersetzen.
Der oder die Geschäftsführer haben umfassende Vertretungsmacht, die Gesellschaft gegenüber Dritten zu vertreten
und alle Handlungen und Geschäfte, die in Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehen, auszuführen, sofern die
Regelungen dieses Artikels 12 beachtet werden.
Der Geschäftsführer oder, bei einer Mehrheit von Geschäftsführern, der Geschäftsführerrat, ist zuständig in allen
Angelegenheiten, die nicht ausdrücklich durch Gesetz oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung zuge-
wiesen sind.
Wenn die Gesellschaft nur einen Geschäftsführers hat, wird sie durch die Unterschrift des Geschäftsführers verpflich-
tet; bei Mehrheit von Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch die alleinige Unterschrift eines jeden Geschäftsführers
verpflichtet.
Die Gesellschafterversammlung, der Geschäftsführer, oder, im Fall einer Mehrheit von Geschäftsführern, jeder einzelne
Geschäftsführer kann seine Befugnisse in Anbetracht bestimmter Handlungen an einen oder mehrere ad-hoc-Bevoll-
mächtigte delegieren. Die Gesellschafterversammlung, der Geschäftsführer, oder im Fall von mehreren Geschäftsführern,
der jeweilige oder die jeweiligen Geschäftsführer, der (die) seine (ihre) Befugnisse delegiert (delegieren), legt (legen) die
Verantwortlichkeiten und die Vergütung des Bevollmächtigten (wenn das Mandat vergütet wird), die Dauer der Bevoll-
mächtigung und alle anderen relevanten Bedingungen fest.
Wenn die Gesellschaft mehr als einen Geschäftsführer hat, werden die Beschlüsse des Geschäftsführerrates mit der
Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Wenn die Gesellschaft
mehrere Geschäftsführer hat, können Beschlüsse nur gefasst werden und kann der Geschäftsführerrat nur handeln, wenn
mehr als die Hälfte der Geschäftsführer anwesend oder vertreten ist.
Der Geschäftsführerrat darf einen Vorsitzenden auf Zeit für jede Sitzung des Geschäftsführerrates wählen. Sofern ein
Vorsitzender gewählt worden ist, führt dieser den Vorsitz der Sitzung, für die er gewählt wurde. Der Vorsitzende auf
Zeit, sofern einer gewählt worden ist, wird von der Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gewählt.
Wenn die Gesellschaft mehr als einen Geschäftsführer hat, muss jede Sitzung wenigstens 24 (vierundzwanzig) Stunden
im Voraus schriftlich per Brief, Fax oder E-Mail gegenüber jedem Geschäftsführer einberufen werden, außer im Falle von
Dringlichkeit. Eine Sitzung des Geschäftsführerrates kann von jedem Geschäftsführer einzeln einberufen werden. Wenn
alle Geschäftsführer, ob anwesend oder vertreten, in der Sitzung erklären, dass sie über die Tagesordnung informiert
wurden, kann auf die Einberufung verzichtet werden. Wenn eine Sitzung des Geschäftsführerrates zu einer Zeit und an
einem Ort abgehalten wird, die vorher in einem Beschluss des Geschäftsführerrates festgelegt wurden, ist eine gesonderte
Einberufung entbehrlich.
Jeder Geschäftsführer kann sich vertreten lassen, indem er per Brief, Fax oder E-Mail einen anderen Geschäftsführer
zu seinem Vertreter bestellt. Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung per Telefonkonferenz, Videokonferenz oder
durch jedes andere ähnliche Kommunikationsmittel, das es den an der Sitzung teilnehmenden Geschäftsführern erlaubt,
persönlich ausgewiesen an der Sitzung und an ihrer Beratung teilzunehmen. Ein Geschäftsführer, der an einer Sitzung des
Geschäftsführerrates im Wege einer Telefon- oder Videokonferenz, oder über jedes andere, ähnliche Kommunikations-
mittel (wie oben beschrieben) teilnimmt, gilt als persönlich anwesend; eine solche über Fernkommunikationsmittel
abgehaltene Sitzung gilt als am Sitz der Gesellschaft abgehalten. Die Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden in einem
Sitzungsprotokoll festgehalten, welches am Sitz der Gesellschaft aufbewahrt wird und von den an der Sitzung teilnehm-
enden oder vertretenen Geschäftsführern, im Falle einer von einem Vorsitzenden geleiteten Sitzung von diesem,
unterschrieben wird. Die Vertretungsvollmachten, sofern diese ausgestellt wurden, sind dem Protokoll als Anlage beizu-
fügen
Ungeachtet der vorhergehenden Bestimmungen können Beschlüsse des Geschäftsführerrates auch auf schriftlichen
Wege gefasst werden (Umlaufbeschlüsse) und aus einem oder mehreren Dokumenten, bestehen die die Beschlüsse ent-
halten, wenn sie von allen Mitgliedern des Verwaltungsrates unterschrieben werden. Als Datum der Beschlussfassung
eines solchen Umlaufbeschlusses gilt das Datum der letzten Unterschrift. Ein Umlaufbeschluss gilt als Sitzung, die in Lu-
xemburg stattgefunden hat.
Art. 13. Verbindlichkeiten des Geschäftsführers/der Geschäftsführer. Der/Die Geschäftsführer (je nachdem) haftet/en
nicht persönlich für im Rahmen ihrer Funktion ordnungsgemäß im Namen der Gesellschaft eingegangene Verbindlichkei-
ten.
137156
L
U X E M B O U R G
Art. 14. Generalversammlung der Gesellschafter. Eine jährliche Generalversammlung des Alleingesellschafters oder
bei einer Mehrheit von Gesellschaftern der Gesellschafter wird am Sitz der Gesellschaft abgehalten, oder an jedem an-
deren in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes befindlichen Ort, der im Einberufungsschreiben angegeben wird.
Andere Versammlungen des Alleingesellschafters oder bei einer Mehrheit von Gesellschaftern der Gesellschafter kön-
nen jederzeit an jedem beliebigen Ort abgehalten werden, der im jeweiligen Einberufungsschreiben angegeben wird.
Solange die Gesellschaft nicht mehr als 25 (fünfundzwanzig) Gesellschafter hat, dürfen Gesellschafterbeschlüsse schrift-
lich von allen Gesellschaftern gefasst werden, ohne dass es einer Generalversammlung bedarf. In diesem Fall, muss ein
präziser Entwurf des Beschlusses oder der anzunehmenden Beschlüsse an jeden Gesellschafter geschickt werden, und
jeder Gesellschafter gibt seine Stimme schriftlich ab (die Abstimmung kann durch Brief, Fax oder E-Mail erfolgen).
Art. 15. Stimmrecht der Gesellschafter, Beschlussfähigkeit und Mehrheit. Ein Alleingesellschafter vereinigt alle Befug-
nisse der Gesellschafterversammlung auf sich.
Im Falle einer Mehrheit von Gesellschaftern hat jeder Gesellschafter das Recht, an gemeinsamen Entscheidungen teil-
zunehmen, unabhängig von seiner Kapitalbeteiligung. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie Anteile auf ihn
entfallen. Im Falle einer Mehrheit von Gesellschaftern werden gemeinsame Beschlüsse rechtskräftig angenommen, wenn
sie durch Gesellschafter, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, angenommen werden.
Änderungen der Satzung der Gesellschaft können, sofern das Gesetz von 1915 nichts anderes zulässt, jedoch nur durch
eine Stimmenmehrheit von Gesellschaftern verabschiedet werden, welche mindestens drei Viertel des Gesellschaftska-
pitals vertreten; die Änderung der Nationalität der Gesellschaft kann nur einstimmig beschlossen werden.
Art. 16. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten
Dezember eines jeden Jahres.
Art. 17. Finanzberichte. Jedes Jahr zum 31. Dezember werden die Bücher der Gesellschaft für das abgelaufene Ge-
schäftsjahr geschlossen und die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung vom Geschäftsführer oder, im Falle einer
Mehrheit von Geschäftsführern, vom Geschäftsführerrat, aufgestellt.
Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.
Art. 18. Gewinnverteilung - Rücklagen. Der Nettogewinn der Gesellschaft errechnet sich aus dem Bruttogewinn nach
Abzug aller Kosten und Abschreibungen. Aus dem Nettogewinn der Gesellschaft sind fünf Prozent (5%) in die Bildung
einer gesetzlichen Rücklage einzubringen, bis diese Rücklage betragsmäßig zehn Prozent (10%) des gezeichneten Gesell-
schaftskapitals erreicht. Die Gesellschafterversammlung entscheidet wie der restliche Jahresreingewinn verwendet wird.
Der Geschäftsführer oder, bei einer Mehrheit von Geschäftsführern die Geschäftsführer, kann bzw. können beschließen,
Zwischendividenden auszuzahlen.
Art. 19. Auflösung - Abwicklung. Nach Auflösung der Gesellschaft wird die Abwicklung durch einen oder mehrere
Liquidatoren, die Gesellschafter sein können, durchgeführt. Der Liquidator bzw. die Liquidatoren werden durch die Ge-
sellschafter unter Festlegung ihrer Befugnisse und Vergütungen ernannt.
Art. 20. Aufsicht und Kontrolle. Gemäß Artikel 200 des Gesetzes von 1915 muss die Gesellschaft einen Wirtschafts-
prüfer (commissaire aux comptes) ernennen, wenn sie mehr als 25 (fünfundzwanzig) Gesellschafter hat. Ein unabhängiger
Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises agréé) muss ernannt werden, wenn die Befreiung nach dem Artike 69(2) des
abgeänderten Gesetzes vom 19 Dezember 2002 über das Handels- und Gesellschaftsregister, wie abgeändert, keine
Anwendung findet.
Art. 21. Verweis auf gesetzliche Bestimmungen. Alle Angelegenheiten, die nicht durch die vorliegende Satzung geregelt
werden, unterliegen dem Gesetz von 1915.
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Die Anteile wurden wie folgt gezeichnet:
Corestate HIGHSTREET HoldCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.000 (fünfunddreizigtausend) Anteile
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.000 (fünfunddreizigtausend) Anteile
Alle Anteile wurden vollständig in bar eingezahlt, so dass die Summe von EUR 35.000,- (fünfunddreizigtausend Euro)
ab sofort der Gesellschaft zur Verfügung steht; ein entsprechender Nachweis wurde dem unterzeichneten Notar gegen-
über erbracht.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt heute und endet am 31. Dezember 2014.
<i>Kosteni>
Die Kosten und Auslagen, die der Gesellschaft für diese Gründung entstehen oder die sie zu tragen hat, belaufen sich
auf ungefähr eintausend zweihundert Euro (EUR 1.200,-).
137157
L
U X E M B O U R G
<i>Generalversammlung der Gesellschafter nach der Gründungi>
Im Anschluss an die Gründung der Gesellschaft hat der alleinige Gesellschafter, der das gesamte gezeichnete Gesell-
schaftskapital auf sich vereinigt, folgende Beschlüsse gefasst:
1. der Geschäftsführerrat hat 1 (ein) Mitglied. Zum alleinigen Geschäftsführer der Gesellschaft wird folgende Person
für eine unbestimmte Zeit ernannt:
Herr Matthias Sprenker, geboren am 21. Februar 1954 in Mülheim an der Ruhr (D), mit Berufsanschrift in L-2163
Luxemburg, 35, avenue Monterey; und
2. der Sitz der Gesellschaft wird unter folgender Anschrift festgesetzt: L-2163 Luxemburg, 35, avenue Monterey.
Der unterzeichnete Notar, der der englischen Sprache mächtig ist, erklärt hiermit, dass auf Ersuchen der erschienenen
Partei diese Urkunde in englischer Sprache verfasst und mit einer deutschen Übersetzung versehen ist und dass im Falle
einer Abweichung des englischen vom deutschen Text der englische Text maßgebend ist.
Worüber die vorliegende Urkunde zum eingangs genannten Datum in Hesperange-Howald erstellt wird.
Als Zeuge wovon wir, der unterzeichnete Notar, unsere Unterschrift und unser Siegel unter dem oben genannten
Datum unter diese Urkunde setzen.
Nach Vorlesen und Erklärung alles Vorstehenden haben der Bevollmächtigte der Erschienenen mit uns, dem unter-
zeichneten Notar, die vorliegende Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: P. CHANTRAIN, M. DECKER.
Enregistré à Diekirch, le 13 août 2014. Relation: DIE/2014/10330. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): Recken.
Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Begehr erteilt.
Diekirch, den 14. August 2014.
Référence de publication: 2014130127/369.
(140147630) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2014.
IT Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 70.476.
DISSOLUTION
In the year two thousand fourteen, on the eighteenth day of July.
Before the undersigned Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
The company Anglo Nordic Ltd with company registration number: 270088, with registered address at Akara Bldg.,
24 De Castro Street, Wickhams Cay, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,
Hereby represented by Mrs Natacha HAINAUX, accountant, residing professionally in L-1724 Luxembourg, 9A, Bou-
levard Prince Henri,
by virtue of a proxy given on July, 10, 2014.
The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, represented as stated above, has requested the undersigned notary to state:
- that it is the sole actual shareholder of IT INVESTMENTS S.à.r.l. (the “Company”), a société à responsabilité limitée,
incorporated by deed of the undersigned notary on June 11
th
, 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, number 688 of September 15
th
, 1999. The Articles of Association have been amended by a notarial
deed on May 2
nd
, 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 672 of 26
th
June
2003;
- that the capital of the Company is fixed at TWO HUNDRED EIGHTY-THREE THOUSAND EUROS (EUR 283,000.-)
represented by TWO HUNDRED EIGHTY-THREE(283) shares with a par value of ONE THOUSAND EURO(EUR
1000.-) each, all fully paid-up;
- that the appearing party, prenamed, is the sole owner of all the shares and declares that it has full knowledge of the
articles of incorporation and the financial standing of the Company;
- that the appearing party, prenamed, in its capacity as sole shareholder of the Company, has resolved to proceed to
the anticipatory and immediate dissolution of the Company and to put it into liquidation;
- that the appearing party, in its capacity as liquidator of the Company, and according to the balance sheet of the
Company as at July 17, 2014, declares that all the liabilities of the Company, including the liabilities arising from the
liquidation, are settled or retained;
137158
L
U X E M B O U R G
The appearing party furthermore declares that:
- the Company's activities have ceased;
- the sole shareholder is thus vested with all the assets of the Company and undertakes to settle all and any liabilities
of the terminated Company, the balance sheet of the Company as at July 17, 2014, being only one information for all
purposes;
- following to the above resolutions, the Company's liquidation is to be considered as accomplished and closed;
- the Company's managers are hereby granted full discharge with respect to their duties;
- there shall be proceeded to the cancellation of all issued shares;
- the books and documents of the company shall be lodged during a period of five years at L-1724 Luxembourg, 9A,
Boulevard Prince Henri.
No confusion of patrimony between the dissolved company and the assets of, nor the reimbursement to the sole
shareholder can be made, before a period of thirty days (article 69 (2) of the law on commercial companies) to be counted
from the day of publication of the present deed, and only if no creditor of the Company currently dissolved and liquidated
has demanded the creation of security.
<i>Costsi>
The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it
by reason of the present deed are estimated approximately at one thousand euros (1.000.-EUR).
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name, civil
status and residence, the said person signed together with the notary this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quatorze, le dix-huit juillet.
Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.
A COMPARU:
La Société Anglo Nordic Ltd, enregistrée sous le numéro:270 088, ayant son siège social à Akara, 24 De Castro Street,
Wickhams Cay, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques,
ici représentée par Madame Natacha HAINAUX, comptable, résidant professionnellement au 9A Boulevard Prince
Henri, L-1724 Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 10 juillet 2014.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire du comparant et le notaire ins-
trumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle comparante, a requis le notaire instrumentant d'acter:
- Qu'elle est la seule et unique associée de la société IT INVESTMENTS S.à r.l. (la «Société»), société à responsabilité
limitée, constituée suivant acte du notaire instrumentant en date du 11 juin 1999, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 688 du 15 septembre 1999. Les statuts ont été modifiés suivant acte notarié en date
du 2 mai 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 672 du 26 juin 2003;
- que le capital social de la Société s'élève à DEUX CENT QUATRE-VINGT-TROIS MILLE EUROS (283.000.-EUR)
représenté par DEUX CENT QUATRE-VINGT-TROIS (283.-) parts sociales d'une valeur nominale de MILLE EURO
(1000.- EUR) chacune, entièrement libérées;
- que la partie comparante, est seule propriétaire de toutes les parts sociales et qu'elle déclare avoir parfaite connais-
sance des statuts et de la situation financière de la Société;
- que la partie comparante, en sa qualité d'associée unique de la Société, a décidé de procéder à la dissolution anticipée
et immédiate de la Société et de la mettre en liquidation;
- que la partie comparante, en sa qualité de liquidateur de la Société et au vu du bilan de la Société au 17 juillet 2014,
déclare que tout le passif de la Société, y compris le passif lié à la liquidation de la Société, est réglé ou dûment provisionné;
La partie comparante déclare encore que:
- l'activité de la Société a cessé;
- l'associée unique est investie de l'entièreté de l'actif de la Société et déclare prendre à sa charge l'entièreté du passif
de la Société qu'il soit connu et impayé, ou inconnu et non encore payé, le bilan au 17 juillet 2014 étant seulement un
des éléments d'information à cette fin;
- suite aux résolutions ci-avant, la liquidation de la Société est à considérer comme accomplie et clôturée;
- décharge pleine et entière est accordée aux gérants de la Société;
137159
L
U X E M B O U R G
- il y a lieu de procéder à l'annulation de toutes les parts sociales;
- les livres et documents de la Société devront être conservés pendant la durée légale de cinq ans à L-1724 Luxembourg,
9A, Boulevard Prince Henri.
Toutefois, aucune confusion de patrimoine entre la société dissoute et l'avoir social de, ou remboursement à, l'associé
unique ne pourra se faire avant le délai de trente jours (article 69 (2) de la loi sur les sociétés commerciales) à compter
de la publication du présent acte et sous réserve qu'aucun créancier de la Société présentement dissoute et liquidée
n'aura exigé la constitution de sûretés.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont évalués approximativement à mille euros (1.000.-EUR).
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la partie comparante l'a
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom
usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: N. HAINAUX, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 21 juillet 2014. Relation: LAC/2014/34208. Reçu soixante-quinze euros (EUR
75,-).
<i>Le Receveuri>
(signé): I. THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 août 2014.
Référence de publication: 2014130151/110.
(140147279) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2014.
Immobilière du X septembre S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 108, avenue du X septembre.
R.C.S. Luxembourg B 189.463.
STATUTS
L'an deux mille quatorze, le premier jour du mois d'août;
Pardevant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
ONT COMPARU:
1. La société anonyme “LRK PARTICIPATIONS S.A.”, établie et ayant son siège social à L-2320 Luxembourg, 104,
Boulevard de la Pétrusse, en cours d'immatriculation au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
ici dûment représentée par deux de ses administrateurs, à savoir:
- Madame Lydie LORANG, avocat, demeurant à L-3721 Rumelange, 45, rue d’Esch, et
- Monsieur Andreas KOMNINOS, avocat, demeurant à L-1898 Kockelscheuer, 11, rue Robert Schuman;
2. Monsieur Paul ZIMMER, retraité, demeurant à L-8080 Bertrange, 63, route de Longwy;
3. La société anonyme “AP PARTICIPATIONS S.A.”, établie et ayant son siège social à L-4975 Bettange-sur-Mess, 25,
rue de la Gare, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 145221,
dûment représentée par deux de ses administrateurs, à savoir:
- Monsieur Jean PIANON, ingénieur civil, demeurant à L-8016 Strassen, 23, rue des Carrières, et
- Madame Angela AVILA JIMENEZ, administrateur de sociétés, demeurant à L-8016 Strassen, 23, rue des Carrières.
ici représentée par Monsieur Andreas KOMNINOS, pré-qualifié, en vertu d'une procuration sous seing privé lui dé-
livrée; laquelle procuration, après avoir été signée “ne varietur” par les comparants et le notaire instrumentant, restera
annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.
Lesquels comparants, ès-qualités qu'ils agissent, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter les statuts d’une société
anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux par les présentes et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de “IMMOBILIERE DU X SEPTEMBRE
S.A.”.
Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
Par simple décision du conseil d'administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l’étranger.
137160
L
U X E M B O U R G
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration
à tout autre endroit de la commune du siège.
Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet l’acquisition, la cession, la mise en location, l’administration et la mise en valeur de ses
propres biens mobiliers et immobiliers.
La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembour-
geoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option d'achat et de toute autre manière des valeurs
immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,
prêts, avances ou garanties.
La société pourra dans le cadre de son activité accorder notamment hypothèque ou se porter caution réelle d’enga-
gements en faveur de tiers.
La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-
nancières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.
Art. 5. Le capital social est fixé à trente-trois mille euros (33.000,- EUR), représenté par trente-trois (33) actions d'une
valeur nominale de mille euros (1.000,-EUR) chacune.
Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires statuant comme
en matière de modification des statuts.
La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-
positions de l’article 49-2 de la loi de 1915.
Art. 6. Les actions de la société sont nominatives.
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et
qui contiendra les indications prévues à l’article 39 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. La propriété
des actions nominatives s'établit par une inscription sur ledit registre.
Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs ou, si la Société
ne comporte qu’un seul administrateur, par celui-ci.
La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l’action est indivise, démembrée ou litigieuse,
les personnes invoquant un droit sur l’action devront désigner un mandataire unique pour représenter l’action à l’égard
de la société. La société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne
ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.
CLAUSE DE PREEMPTION
La cession des actions de la société à un tiers ou au profit d'actionnaires est soumise au respect du droit de préemption
des actionnaires défini ci-après:
L'actionnaire cédant doit notifier son projet au conseil d’administration par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception en indiquant les informations sur le cessionnaire (nom, adresse et nationalité ou, s'il s'agit d'une personne
morale, dénomination, siège social, capital, numéro d'immatriculation, identité des actionnaires et des dirigeants), le
nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix et les conditions de la cession projetée.
Dans un délai de TRENTE (30) JOURS de ladite notification, le conseil d’administration notifiera ce projet aux autres
actionnaires, individuellement, par lettre recommandée avec accusé de réception, qui disposeront d'un délai de TRENTE
(30) JOURS pour se porter acquéreurs des actions à céder, dans la proportion de leur participation au capital.
Chaque actionnaire exerce son droit de préemption en notifiant au conseil d’administration le nombre d'actions qu'il
souhaite acquérir, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A l’expiration de ce dernier délai, le conseil d’administration devra faire connaître par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception les résultats de la préemption à l’actionnaire cédant.
Si les droits de préemption sont supérieurs au nombre d'actions proposées à la vente, les actions concernées sont
réparties par le conseil d’administration entre les actionnaires qui ont notifié leur intention d'acquérir au prorata de leur
participation au capital et dans la limite de leurs demandes.
Si les offres d'achat sont inférieures au nombre d'actions proposées à la vente, les droits de préemption seront réputés
n'avoir jamais été exercés. Dans ce cas, et sous réserve de l’agrément ci-après prévu, l’actionnaire cédant pourra librement
céder ses actions au cessionnaire mentionné dans la notification.
137161
L
U X E M B O U R G
Toutefois, l’actionnaire cédant peut demander le bénéfice de l’exercice du droit de préemption à concurrence du
nombre de titres pour lequel il aura été notifié par les autres actionnaires et procéder à la cession du solde des actions
qu'il envisageait de céder, conformément aux dispositions des statuts.
Lorsque tout ou partie des actions dont la cession est projetée n'aura pas été préemptée dans les conditions ci-dessus
prévues, le cédant devra, si le cessionnaire est non actionnaire, se soumettre à la procédure d'agrément suivante:
CLAUSE D’AGREMENT
La cession des actions à un tiers à quelque titre que ce soit est soumise à l’agrément préalable de l’assemblée générale
des actionnaires.
Le cédant doit notifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une demande d'agrément au conseil
d’administration de la société en indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des actions dont la
cession est envisagée et le prix offert. Cette demande d'agrément est transmise par le conseil d’administration aux
actionnaires.
L'agrément résulte d'une décision collective des actionnaires statuant à la majorité des voix des actionnaires disposant
du droit de vote, les actions du cédant n'étant pas prises en compte pour le calcul de cette majorité.
La décision d'agrément ou de refus d'agrément n'a pas à être motivée. Elle est notifiée au cédant par lettre recom-
mandée. A défaut de notification dans les SOIXANTE (60) JOURS qui suivent la demande d'agrément, l’agrément est
réputé acquis.
En cas d'agrément, l’actionnaire cédant peut réaliser librement la cession aux conditions prévues dans la demande
d'agrément.
En cas de refus d'agrément, la société est tenue, dans un délai de SOIXANTE (60) JOURS à compter de la notification
du refus, de faire acquérir les actions, soit par un actionnaire ou par un tiers, soit, avec le consentement du cédant, par
la société, en vue d'une réduction du capital.
A défaut d'accord entre les parties, le prix des actions est déterminé par voie d'expertise.
Le cédant peut à tout moment aviser le conseil d’administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, qu'il renonce à la cession de ses actions.
Si, à l’expiration du délai de SOIXANTE (60) JOURS, l’achat par l’actionnaire, le tiers ou la société venant se substituer
au cessionnaire initial n'est pas réalisé, l’agrément est considéré comme donné.
Les dispositions qui précèdent sont applicables à toutes les cessions, que lesdites cessions interviennent par voie
d'apport, de fusion, de partage consécutif à la liquidation d'une société associée, de transmission universelle de patrimoine
d'une société ou par voie d'adjudication publique en vertu d'une décision de justice ou autrement.
Elles peuvent aussi s'appliquer à la cession des droits d'attribution en cas d'augmentation de capital par incorporation
de réserves, primes d'émission ou bénéfices, ainsi qu'en cas de cession de droits de souscription à une augmentation de
capital par voie d'apports en numéraire ou de renonciation individuelle au droit de souscription en faveur de personnes
dénommées.
Toute cession réalisée en violation de cette clause d'agrément est nulle.
Art. 7. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non. Toutefois, s'il est constaté lors d'une assemblée des actionnaires que la société n’a plus qu’un actionnaire unique,
la composition du conseil d’administration peut être limitée à un administrateur jusqu’à l’assemblée générale ordinaire
suivant la constatation de l’existence de plus d’un actionnaire. L’administrateur unique, le cas échéant, disposera de
l’ensemble des prérogatives dévolues au conseil d’administration par la Loi et par les présents statuts. Lorsque, dans les
présents statuts, il est fait référence au conseil d’administration, il y a lieu d’entendre «administrateur unique» ou «conseil
d’administration», selon le cas.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement;
dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 8. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet
social; tout ce qui n'est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d'administration est autorisé à procéder à
un versement d'acomptes sur dividendes.
Le conseil d'administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat
entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier électronique, étant admis.
En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier élec-
tronique.
137162
L
U X E M B O U R G
Les réunions du conseil d’administration pourront se tenir également par conférence téléphonique ou par vidéo-
conférence.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale
de celle-ci.
Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs,
ou, en cas d’un administrateur unique, par la signature de ce dernier, sans préjudice des décisions à prendre quant à la
signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article
8 des statuts.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 10. L'année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 11. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 1
er
jeudi du mois de mai à 14.00 heures au siège
social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d'administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d'actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Art. 13. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 14. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application
partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2014.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2015.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
1. La société “LRK PARTICIPATIONS S.A.”, pré-désignée, onze actions, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2. Monsieur Paul ZIMMER, pré-qualifié, onze actions, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3. La société “AP PARTICIPATIONS S.A.”, pré-désignée, onze actions, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Total: trente-trois actions, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Toutes ces actions ont été libérées intégralement en numéraire, de sorte que la somme de trente-trois mille euros
(33.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instru-
mentant, qui le constate expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août
de 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, et en confirme expressément l’accomplissement.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants pré-mentionnés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1. Le siège social est établi à L-2550 Luxembourg, 108, Avenue du X Septembre.
2. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires aux comptes à un (1).
3. Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
137163
L
U X E M B O U R G
a) Monsieur Paul ZIMMER, retraité, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 2 février 1931, demeurant
à L-8080 Bertrange, 63, route de Longwy;
b) Monsieur Andreas KOMNINOS, avocat, née à Athènes (Grèce), le 24 juin 1972, demeurant à L-1898 Kockelscheuer,
11, rue Robert Schuman;
c) Monsieur Jean PIANON, ingénieur civil, né à Tambre Dalpago (Italie), le 13 septembre 1950, demeurant à L-8016
Strassen, 23, rue des Carrières.
4. Monsieur Justin DOSTERT, expert fiscal, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 1
er
janvier 1939,
demeurant à L-5969 Itzig, 93, rue de la Libération, est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes.
5. Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale
annuelle de 2020.
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, est évalué approximativement à mille euros.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et
demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: L. LORANG, A. KOMNINOS, P. ZIMMER, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 4 août 2014. LAC/2014/36777. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
Luxembourg, le 11 août 2014.
Référence de publication: 2014130147/217.
(140147091) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2014.
Awas Luxembourg 6220 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 189.522.
STATUTES
In the year two thousand fourteen on the eleventh day of August.
Before Us, Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,
THERE APPEARED:
AWAS Aviation Trading Limited, existing under the form of a company limited by shares, duly incorporated and validly
existing under the laws of Ireland having its registered office at 70, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland, registered
with the Register of Companies of Ireland under number 432902,
here represented by Me. Pawel Hermelinski, Avocat à la Cour, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given
under private seal dated 25 July 2014.
The said proxy after having been signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
The above named person in the capacity in which it acts, has declared its intention to incorporate by the present deed
a “société anonyme” and to draw up the articles of association of it as follows:
Art. 1. Form, Denomination. There is hereby established by the subscribed and all those who may become owners of
the shares hereafter issued a company in the form of a société anonyme (public company limited by shares), under the
name of AWAS Luxembourg 6220 S.A. (the “Corporation”). The Corporation will be governed by the laws pertaining
to such an entity and in particular by the Luxembourg law on commercial companies dated 10 August 1915, as amended
(the “Law”) as well as by the articles of incorporation (the “Articles of Incorporation”) which also specify the rules applying
to a one-member corporation.
Art. 2. Duration. The Corporation is established for an unlimited period. The Corporation may be dissolved at any
moment by a resolution of the shareholder(s) adopted in the manner required to amend the Articles of Incorporation.
Art. 3. Object.
3.1 The object of the Corporation is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign
companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or
otherwise of stocks, bonds, debentures, notes, any form of beneficial interest and other securities of any kind, and the
137164
L
U X E M B O U R G
ownership, administration, development and management of its portfolio. The Corporation may also hold interests in
partnerships.
3.2 In a general fashion it may grant directly or indirectly assistance including financial assistance, in any form whatsoever,
to any company belonging to the same group as the Corporation, take any controlling and supervisory measures and
carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.
3.3 The Corporation may in particular enter into the following transactions, it being understood that the Corporation
will not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a
regulated activity of the financial sector:
- to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility or loan and raise funds through, including, but
not limited to, the issue, on a private basis, of bonds, notes, promissory notes and other debt or equity instruments, the
use of financial derivatives or otherwise;
- to advance, lend or deposit money or give credit to or with or to subscribe to or purchase any debt instrument
issued by any Luxembourg or foreign entity on such terms as may be thought fit and with or without security;
- to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or
charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for the
performance of any contracts or obligations of the Corporation and of any of the affiliated companies, or any managers
or officers of the Company or any of the affiliated companies, within the limits of law.
3.4 The Corporation can perform all legal, commercial, industrial, technical and financial investments or operation, as
well as any transactions on real estate or on movable property and in general, all transactions which are necessary to
fulfill its object as well as all operations connected directly or indirectly to facilitating the accomplishment of its purpose
in all areas described above.
Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Corporation is established in Luxembourg City. The registered office may be transferred
within the City of Luxembourg by decision of the board of directors. Branches or other offices may be established either
in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.
4.2 If the board of directors considers that political, economic or social events occurred or threaten to occur which
are likely to affect the normal activities at the registered office or communications from the registered office with abroad,
the registered office may be provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned
to normal. Such measures will not affect the Corporation's nationality which will notwithstanding such provisional transfer
of the registered office remain a Luxembourg Corporation.
Art. 5. Capital - Shares and share certificates.
5.1 Capital
The subscribed capital of the Corporation is set at EUR 250,000.- (two hundred and fifty thousand Euros) divided into
250,000.- (two hundred and fifty thousand) ordinary shares all with a nominal value of EUR 1.- (one Euro) per share.
5.2 Shares
5.2.1 The shares shall be bearer or in registered form at the shareholders' choice.
5.2.2 The Corporation shall consider the person in whose name the shares are registered in the register of shareholders
as the full owner of such shares.
5.2.3 Certificates stating such inscription shall be delivered to the shareholders. Transfer of registered shares shall be
effected by a declaration of transfer inscribed in the register of shareholders, dated and signed by the transferor and the
transferee or by persons holding suitable powers of attorney to act therefore. Transfer may also be effected by delivering
the certificate representing the share to the Corporation, duly endorsed to the transferee.
5.2.4 The Corporation can proceed to the repurchase of its own shares within the bounds laid down by the law.
Art. 6. Increase of capital. The capital of the Corporation may be increased or reduced by a resolution of the share-
holders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation, as prescribed in Article 16
hereof.
Art. 7. Meetings of shareholders - General.
7.1 Any regularly constituted meeting of shareholders of the Corporation shall represent the entire body of share-
holders of the Corporation.
The general meeting of shareholders shall have the widest powers to adopt or ratify any action relating to the Company.
In particular, the general meetings of shareholders shall have competence in all matters where the board of directors, in
its sole discretion, desires the formal approval of the general meeting of shareholders.
7.2 The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of
the Corporation, unless otherwise provided herein.
7.3 Each ordinary share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing
another person as his proxy in writing or by fax or telegram or telex.
137165
L
U X E M B O U R G
7.4 Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a
simple majority of those present and voting.
7.5 The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take
part in any meeting of shareholders.
7.6 If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have
been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.
Art. 8. Board of directors.
8.1 The Corporation shall be managed by a board of directors composed of at least 3 (three) members who need not
to be shareholders of the Corporation.
8.2 The directors shall be appointed at the annual general shareholders' meeting for a period of maximum 6 (six) years
and shall hold office until their successors are elected.
8.3 A director may be removed with or without cause and replaced at any time by resolution adopted by the share-
holders.
8.4 In the event of one or more vacancies on the board of directors because of death, retirement or otherwise, the
remaining directors must appoint within 30 (thirty) business days one or more successors to fill such vacancies until the
next meeting of shareholders.
8.5 The members of the board of directors shall not be compensated for their services as director, unless otherwise
resolved by the general meeting of shareholders. The Corporation shall reimburse the directors for reasonable expenses
incurred in the carrying out of their office, including reasonable travel and living expenses incurred for attending meetings
on the board.
Art. 9. Procedures of meeting of the board.
9.1 The board of directors may choose from among its members a chairman and a vice-chairman. It may also choose
a secretary, who need not be a director and who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the board
of directors and of the shareholders.
9.2 The chairman shall preside at all meetings of shareholders and the board of directors, but in his absence the
shareholders or the board of directors may appoint another chairman pro tempore by vote of the majority present at
any such meeting.
9.3 The board of directors shall meet upon call by the chairman or 2 (two) directors at the place indicated in the
convening notice. The convening notice, containing the agenda, shall be sent by letter (sent by express mail or special
courier), telegram, telex or telefax to the domicile of the directors at least 10 (ten) days before the date set for the
meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the
convening notice and in which case notice of at least 24 hours prior to the hour set for such meeting by telefax and/or
telegram shall be sufficient. This notice may be waived by the consent in writing or by fax or telegram or telex of each
director. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule
previously adopted by resolution of the board of directors. All reasonable efforts will be afforded so that, sufficiently in
advance of any meeting of the board each director is provided with a copy of the documents and/or materials to be
discussed or passed upon by the board at such meeting.
9.4 Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by fax, or telegram or
telex another director as his proxy. The use of video conferencing equipment and conference call shall be allowed and
the directors using this technology shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by phone.
After deliberation, votes may also be cast in writing or by fax or telegram or telex or by telephone provided in such latter
event such vote is confirmed in writing.
9.5 The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or repre-
sented at the meeting of the board of directors.
Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting.
9.6 In the event that any director or officer of the corporation may have any adverse personal interest in any transaction
of the corporation, such director or officer shall make known to the board of directors such personal interest and shall
not consider, or vote on such transaction, and such directors', or officers' interest therein shall be reported by the board
of directors to the next succeeding meeting of shareholders subject to the responsibility of the board of directors.
9.7 Resolutions signed by all the members of the board of directors shall have the same effect as if as resolutions taken
during a board of directors' meeting.
9.8 The discussions of the board of directors shall be conducted in the English language.
Art. 10. Minutes of meetings of the board.
10.1 The resolutions of the board of directors shall be recorded in the minutes, to be signed by the chairman (or in
his absence by the chairman pro tempore who presided at such meeting) and the secretary, or by a notary public, and
recorded in the corporate book of the Corporation.
137166
L
U X E M B O U R G
10.2 Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed
by the chairman, by the secretary or by 2 (two) directors.
Art. 11. Powers of the board.
11.1 The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition
in the Corporation's interests. All powers not expressly reserved by law or by the present Articles of Incorporation to
the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.
11.2 The board of directors may delegate, with prior consent of the general meeting of shareholders, its powers to
conduct the daily management and affairs of the Corporation and the representation of the Corporation for such ma-
nagement and affairs, to one of the members of the board of directors who shall be called the managing director. It may
also confer all powers and special mandates to any person who need not to be a director, appoint and dismiss all officers
and employees and determine their emoluments.
Art. 12. Binding signature. The Corporation will be bound by the joint signature of at least 2 (two) directors of the
Corporation, by the single signature of the managing director within the limits of the daily management or by the joint
or single signature of any person to whom such signatory power shall have been delegated by the board of directors.
Art. 13. Statutory auditor. The operations of the Corporation shall be supervised by 1 (one) or more statutory auditors
as foreseen by law who need not to be shareholder. If there is more than one statutory auditor, the statutory auditors
shall act as a collegium and form the board of auditors. The statutory auditors shall be appointed by the annual general
meeting of shareholders for a period ending at the date of the next annual general meeting of shareholders.
Art. 14. Appropriation of profits.
14.1 Legal Reserve
From the annual net profits of the Corporation, 5% (five per cent) shall be allocated to the reserve required by law.
This allocation shall cease to be required as soon and as long as such surplus reserve amounts to 10% (ten per cent) of
the subscribed capital of the Corporation.
14.2 Dividends
14.2.1 The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, shall determine how
the remainder of the annual net profits shall be disposed of and may declare from time to time ordinary dividends without
ever exceeding the amounts proposed by the board of directors.
14.2.2 Interim dividends may be distributed, subject to the conditions laid down by law, upon decision of the board of
directors and report by the statutory auditors.
Art. 15. Dissolution and liquidation.
15.1 The Corporation may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted in the manner required
for amendment of these Articles of Incorporation as prescribed in Article 16 hereof.
15.2 In the event of dissolution of the Corporation, liquidation shall be carried out by 1 (one) or several liquidators
named by the meeting of shareholders affecting such dissolution and which shall determine their powers and their com-
pensation.
Art. 16. Amendment of articles. These Articles of Incorporation may be amended from time to time by a meeting of
shareholders, subject to the quorum and voting requirements provided by the laws of Luxembourg.
Art. 17. Governing law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance
with the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.
Art. 18. Annual general meeting of shareholders.
18.1 The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law at the registered
office of the Corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the last
day of the month May at 5:00 pm.
18.2 If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the immediately
preceding bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of
the board of directors, exceptional circumstances so require.
18.3 Other meetings of shareholders, ordinary and extraordinary, may be held at such place and time as may be
specified in the respective notice of meetings. They may be held at the registered office or in any other place.
Art. 19. Accounting year. The accounting year of the Corporation shall begin on the 1
st
of December and shall
terminate on the 30
th
November of each year.
<i>Transitory provisioni>
The first accounting year will begin at the incorporation of the Corporation and end on the 30
th
November 2014.
The first annual meeting will be held in 2015.
137167
L
U X E M B O U R G
<i>Subscription and paymenti>
The Articles of Incorporation thus been established, the party appearing, duly represented, declares to subscribe all
the two hundred and fifty thousand (250,000.-) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00.-) each.
The two hundred and fifty thousand (250,000.-) shares have been partially paid up at 25% of their nominal value in
cash by an amount of sixty two thousand five hundred Euros (EUR 62,500.-).
Proof of the contribution in cash of the sixty two thousand five hundred Euros (EUR 62,500.-) has been given to the
undersigned notary by a bank certificate so that as of now said amount is at the free disposal of the Corporation, which
is expressly acknowledged by the undersigned notary.
<i>Statementi>
The undersigned notary declares that the conditions set forth in article 26, 26-3 and 26-5 of the law dated 10 August
1915 on commercial companies, as amended, have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfillment.
<i>Decisions taken by the sole shareholderi>
The aforementioned appearing party, representing the whole of the subscribed share capital, has adopted the following
resolutions as sole shareholder:
1. The number of director is fixed at three (3) and the number of the statutory auditor at one (1).
Mr. Frederic Mireur, born on 9 January 1963 in Marseille, France, professionally residing at Block B Riverside IV Sir
John Rogerson's Quay Dublin 2, Ireland is appointed as director of the Corporation;
Mr. Gérard Maîtrejean, attorney at law, born on 13 June 1967 in Charleroi, Belgium, and residing professionally at 291,
Route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, is appointed as director of the Corporation;
Mr. Frédéric Feyten, attorney at law, born on 2 July 1966, in Bonheiden in Belgium, and residing professionally at 291,
Route d'Arlon, L-1150 Luxembourg is appointed as director of the Corporation;
2. Exaudit S.A., having its registered office at 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg registered with the Lu-
xembourg Trade and Companies Register under number B 124.982, is appointed as statutory auditor.
3. The terms of office of the directors and the statutory auditor will expire after the annual general meeting of sha-
reholders, in 2020.
4. The registered office of the Corporation is established at L-2453 Luxembourg, rue Eugène Ruppert, 19.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately EUR 2,300.-.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder signed together with the
notary the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quatorze, le onze août.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand Duché du Luxembourg,
A COMPARU:
AWAS Aviation Trading Limited, existante sous la forme d'un company limited by shares, dûment constituée et existant
valablement sous les lois Irlandaise, ayant son siège social à 70, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlande, enregistrée
auprès du Registre des Sociétés de l'Irlande sous le numéro 432902,
ici représenté par Me. Pawel Hermelinski, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration
donnée sous seing privé datée du 25 juillet 2014.
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées «ne varietur» par la partie comparante et le notaire ins-
trumentant, annexées au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.
Lequel comparant, ès-qualités, qu'il agit, a requis du notaire instrumentant qu'il dresse l'acte constitutif d'une société
anonyme qu'il déclare former et dont les statuts ont été arrêtés comme suit:
Art. 1
er
. Forme, Dénomination. Il est constitué par les présentes par le comparant et tous ceux qui deviendront
propriétaires des actions ci-après émises une société anonyme luxembourgeoise, sous le nom de AWAS Luxembourg
6220 S.A. (la «Société»). La Société sera régie par les lois relatives à cette entité et en particulier par la Loi Luxembour-
geoise sur les sociétés commerciales datée du 10 août 1915, telle qu'amendée (la «Loi») ainsi que par les statuts (les
«Statuts») lesquels précisent notamment les règles applicables à une société unipersonnelle.
137168
L
U X E M B O U R G
Art. 2. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée. La Société peut être dissoute à tout moment par
une décision du ou des actionnaire(s) délibérant dans les conditions requises pour un changement des Statuts.
Art. 3. Objet.
3.1 L'objet de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembour-
geoises et étrangères, l'acquisition par l'achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par vente,
échange ou autre, d'actions, d'obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres titres de quelque forme que ce
soit, et la propriété, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut en outre prendre
des participations dans des sociétés de personnes.
3.2 D'une façon générale, elle peut accorder une assistance directe ou indirecte incluant une assistance financière, sous
quelques formes que ce soit, à toute société appartenant au même groupe que la Société, prendre toutes mesures de
contrôle et de supervision et accomplir toute opération qui pourrait être utile à l'accomplissement et au développement
de son objet.
3.3 La Société pourra, en particulier, être engagée dans les opérations suivantes, étant entendu que la Société n'entrera
dans aucune opération qui pourrait l'amener à être engagée dans toute activité qui serait considérée comme une activité
réglementée du secteur financier:
conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit ou prêt et réunir des fonds,
notamment, par l'émission, sur une base privée, de titres, d'obligations, notes, de billets à ordre et autres instruments
convertibles ou non de dette ou de capital, ou utiliser des instruments financiers dérivés ou autres;
avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ou avec ou de souscrire à ou acquérir tous instruments de
dette, avec ou sans garantie, émis par une entité luxembourgeoise ou étrangère, pouvant être considérée comme per-
formante;
accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement personnel
ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre de ces méthodes,
pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de sociétés apparentées ou tout gérant ou employés
de la Société de ou société apparentées, dans les limites autorisées par la loi.
3.4 La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute
transaction sur des biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que toute transaction qu'elle estime nécessaire ou utile direc-
tement ou indirectement à l'accomplissement et au développement de son objet dans le cadre des domaines susmen-
tionnées.
Art. 4. Siège social.
4.1 Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-ville. Le siège social pourra être transféré à l'intérieur de la
Ville de Luxembourg par décision du conseil d'administration. Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis au
Grand-Duché du Luxembourg ou à l'étranger par décision du conseil d'administration.
4.2 Si le conseil d'administration détermine que des événements d'ordre politique, économique ou social se sont
produits ou sont imminents, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication de ce siège
avec l'étranger, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'au moment où les circonstances
seront redevenues complètement normales. De telles mesures ne changent en rien la nationalité de la Société, qui restera
luxembourgeoise malgré le transfert temporaire de son siège social.
Art. 5 Capital - Actions et certificats d'actions.
5.1 Capital
Le capital social souscrit de la Société est fixé à 250.000,- EUR (deux cent cinquante mille euros) divisé en 250.000
(deux cent cinquante mille) actions ordinaires ayant une valeur nominale de 1,-EUR (un Euro) chacune.
5.2 Actions
5.2.1 Les actions seront nominatives ou au porteur, au gré de l'actionnaire.
5.2.2 La Société reconnaît les personnes au nom desquelles les actions sont enregistrées dans le registre des action-
naires comme les pleins propriétaires de ces actions.
5.2.3 Des certificats attestant cette inscription seront délivrés aux actionnaires. La cession d'actions nominatives devra
être effectuée par une déclaration de cession inscrite au registre des actionnaires, datée et signée par le cédant et le
cessionnaire ou par toutes personnes dûment mandatées à cet effet. Une cession pourra aussi être effectuée par le dépôt
à la Société du certificat d'actions nominatives, dûment endossé en faveur du cessionnaire.
5.2.4 La Société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Art. 6. Augmentation de capital. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit par décision des
actionnaires adoptée dans les formes requises pour les modifications ces Statuts, telles que prévues à l'article 16 ci-après.
Art. 7. Assemblées des actionnaires - Général.
7.1 Chaque assemblée des actionnaires de la Société, régulièrement constituée, représente l'intégralité des actionnaires
de la Société.
137169
L
U X E M B O U R G
L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour adopter ou ratifier les actes qui intéressent
la Société. En particulier, l'assemblée générale des actionnaires sera compétente dans tous les domaines dans lesquels le
conseil d'administration, à sa seule discrétion, souhaite une approbation formelle de l'assemblée générale des actionnaires.
7.2 Le quorum et le temps requis par la loi sont applicables aux convocations et à la tenue des assemblées des ac-
tionnaires de la Société, sauf disposition contraire dans les présents Statuts.
7.3 Chaque action ordinaire donne droit à une voix. Un actionnaire peut agir à toute assemblée des actionnaires en
désignant une autre personne comme mandataire, par écrit, par fax, par télégramme ou par télex.
7.4 Sauf stipulations contraires de la loi, les décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires dûment convo-
quée seront prises à la majorité simple des présents et votants.
7.5 Le conseil d'administration pourra déterminer toutes les autres conditions qui devront être remplies par les ac-
tionnaires pour pouvoir participer à toute assemblée des actionnaires.
7.6 Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent qu'ils ont été
informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée pourra se tenir sans convocation ni publication préalable.
Art. 8. Conseil d'administration.
8.1 La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de 3 (trois) membres au moins, qui n'ont pas
besoin d'être actionnaires de la Société.
8.2 Les administrateurs seront désignés lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période de 6
(six) ans maximum et resteront en fonction jusqu'à l'élection de leurs successeurs.
8.3 Un administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif et remplacé à tout moment sur décision adoptée par
les actionnaires.
8.4 En cas de vacance d'un ou plusieurs postes d'administrateur, pour cause de décès, retraite ou autre, les adminis-
trateurs restants doivent désigner dans les 30 (trente) jours ouvrables suivants, un ou plusieurs successeurs pour palier
ces postes vacants, jusqu'à la prochaine assemblée des actionnaires.
8.5 Les membres du conseil d'administration ne seront pas rémunérés pour leurs services en tant qu'administrateur,
sauf s'il en est décidé autrement par l'assemblée générale des actionnaires. La Société pourra rembourser aux adminis-
trateurs les dépenses raisonnables survenues lors de l'exécution de leur mandat, y compris les dépenses raisonnables de
voyage et de logement survenus lors de la participation à des réunions du conseil d'administration.
Art. 9. Modalités de réunion du conseil d'administration.
9.1 Le conseil d'administration pourra choisir parmi ses membres, un président et un vice-président. Il pourra aussi
choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être un administrateur et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux
des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales.
9.2 Le président préside toutes les assemblées des actionnaires et les réunions du conseil d'administration, mais en
son absence, les actionnaires ou le conseil d'administration pourront nommer un autre président pro tempore par vote
à la majorité des présents à ces assemblées ou à ces réunions du conseil d'administration.
9.3 Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou de 2 (deux) administrateurs au lieu indiqué
dans la convocation. La convocation contenant l'agenda doit être envoyée par lettre (courrier express ou courrier spécial),
par fax, par télégramme ou par télex au domicile de chacun des administrateurs au moins 10 (dix) jours avant la date
prévue de la réunion, sauf dans des circonstances d'urgence, dont la nature devra figurer dans la convocation, il suffira
que la convocation soit envoyée au moins 24 heures avant l'heure fixée pour la réunion, par télex, et/ou télégramme.
Cette convocation peut être levée par le consentement de chaque administrateur donné par écrit, par fax, télégramme
ou télex. Une convocation séparée n'est pas requise pour les réunions tenues aux heures et lieux indiqués dans l'emploi
du temps préalablement adopté par une décision du conseil d'administration. Tout effort raisonnable sera fait pour que
chaque administrateur obtienne suffisamment à l'avance de chaque réunion du conseil une copie des documents et /ou
matériaux à discuter et/ou à approuver à cette réunion.
9.4 Chaque administrateur peut agir à toute réunion du conseil d'administration en nommant un autre administrateur,
par écrit, par fax, par télégramme ou par télex, comme son mandataire. L'utilisation d'équipement pour conférences vidéo
et conférences téléphoniques est autorisée et les administrateurs utilisant ces technologies sont présumés être présents
et seront autorisés à voter par vidéo ou par téléphone. Après délibération, les votes pourront aussi être exprimés par
écrit, fax, télégramme, télex ou par téléphone, dans ce dernier cas le vote doit être confirmé par écrit.
9.5 Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement, seulement si la majorité au moins des admi-
nistrateurs est présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.
Les décisions seront prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.
9.6 Dans le cas où un administrateur ou fondé de pouvoir de la Société pourrait avoir un intérêt personnel opposé
dans une transaction de la société, cet administrateur ou fondé de pouvoir devra faire connaître au conseil d'administration
son intérêt personnel et ne pourra délibérer ou voter une telle transaction, et le conseil d'administration devra rendre
compte de l'intérêt de cet administrateur ou fondé de pouvoir, à la prochaine assemblée des actionnaires sous la res-
ponsabilité du conseil d'administration.
137170
L
U X E M B O U R G
9.7 Les résolutions signées par tous les membres du conseil d'administration auront le même effet que celles prises
lors d'une réunion du conseil d'administration.
9.8. Les débats du conseil d'administration seront tenus en langue anglaise.
Art. 10. Procès-verbaux des conseils d'administration.
10.1. Les résolutions du conseil d'administration seront constatées par des procès-verbaux, qui sont signés par le
président (ou en son absence par le président pro tempore qui a présidé cette réunion) et par le secrétaire, ou par un
notaire et seront déposées dans les livres de la Société.
10.2 Les copies et extraits de ces procès-verbaux qui pourraient être produits en justice ou autrement seront signés
par le président, par le secrétaire ou par 2 (deux) administrateurs.
Art. 11. Pouvoirs du conseil d'administration.
11.1 Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour effectuer tous les actes d'administration
ou de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou les
présents Statuts à l'assemblée générale, tombent sous la compétence du conseil d'administration.
11.2 Le conseil d'administration pourra déléguer, avec l'accord préalable de l'assemblée des actionnaires, ses pouvoirs
de gestion journalière et les affaires courantes de la Société ainsi que la représentation de la Société dans cette gestion
et ces affaires, à un des membres du conseil d'administration, qui sera appelé administrateur - délégué. Il pourra en outre
conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes, qui n'ont pas besoin d'être administrateur, afin de
nommer et révoquer tous agents et employés et de fixer leurs émoluments.
Art. 12. Signature. La Société est engagée par la signature conjointe d'au moins 2 (deux) administrateurs de la Société,
par la signature unique de l'administrateur - délégué dans les limites de la gestion journalière, ou par la signature conjointe
ou unique de toute personne à laquelle un tel pouvoir de signature a été délégué par le conseil d'administration.
Art. 13. Commissaires aux comptes. Les opérations de la Société sont contrôlées par 1 (un) ou plusieurs commissaires
aux comptes, tel que prévu par la loi et qui n'ont pas besoin d'être actionnaires. S'il y a plus d'un commissaire aux comptes,
les commissaires aux comptes doivent agir en collège et former le conseil des commissaires aux comptes. Les commis-
saires aux comptes sont nommés par l'assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période se terminant à la
prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires.
Art. 14. Affectation des bénéfices.
14.1 Réserve Légale
Du bénéfice net annuel de la Société, 5% (cinq pour cent) seront alloués à la réserve requise par la loi. Ces allocations
cesseront d'être obligatoires dès que, et aussi longtemps que, cette réserve atteindra 10% (dix pour cent) du capital social
souscrit de la Société.
14.2 Dividendes
14.2.1 L'assemblée générale des actionnaires, sur recommandation du conseil d'administration, déterminera de quelle
façon il sera disposé du solde du bénéfice annuel net et pourra déclarer de temps à autre des dividendes ordinaires sans
jamais excéder les montants proposés par le conseil d'administration.
14.2.2 Des dividendes intermédiaires pourront être distribués, sous réserve des conditions prévues par la loi, sur
décision du conseil d'administration et suivant rapport des commissaires aux comptes.
Art. 15. Dissolution et liquidation.
15.1 La Société pourra être dissoute à tout moment en vertu d'une décision des actionnaires prise dans les formes
requises pour les modifications des Statuts, telles que décrites à l'article 16 ci-après.
15.2 En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par 1 (un) ou plusieurs liquidateurs nommés par
l'assemblée générale des actionnaires décidant la dissolution, laquelle déterminera en outre leurs pouvoirs et rémunéra-
tions.
Art. 16. Modification des statuts. Ces Statuts pourront être modifiés de temps en temps par l'assemblée des action-
naires selon le quorum et conditions de vote requis par les lois du Grand-Duché du Luxembourg.
Art. 17. Loi applicable. Tous les points non réglés par ces Statuts seront déterminés conformément à la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
Art. 18. Assemblée générale annuelle.
18.1 L'assemblée générale annuelle des actionnaires sera tenue, conformément à la loi luxembourgeoise, au siège social
de la Société, ou à tout autre endroit à Luxembourg stipulé dans la convocation, le dernier jour du mois de mai à 17:00
heures.
18.2 Si ce jour n'est pas un jour ouvrable bancaire à Luxembourg, l'assemblée générale annuelle sera tenue le jour
ouvrable bancaire précédant. L'assemblée générale pourra être tenue à l'étranger, si de l'opinion absolue et finale du
conseil d'administration, des circonstances exceptionnelles le requièrent.
137171
L
U X E M B O U R G
18.3 D'autres assemblées des actionnaires, ordinaires ou extraordinaires, pourront être tenues en lieu et place tels
que spécifié dans les convocations des assemblées respectives. Elles peuvent être tenues au siège social ou à tout autre
lieu.
Art. 19. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le premier jour du mois de décembre et se termine
le 30 novembre de chaque année.
<i>Dispositions transitoiresi>
La première année sociale commencera le jour de la constitution de la Société et finira le 30 novembre 2014.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2015.
<i>Souscription et paiementi>
Les Statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, le comparant, dûment représenté, déclare souscrire toutes les deux
cents cinquante mille (250.000) actions d'une valeur nominale de un Euro (EUR 1.00.-) chacune.
Les deux cent cinquante mille (250.000) actions ont été partiellement libérées à concurrence de 25% de leur valeur
nominal en espèces par un montant de soixante deux mille cinq cents Euros (EUR 62.500,-).
La preuve de l'apport en espèces de soixante deux mille cinq cents Euros (EUR 62.500,-) a été rapportée au notaire
instrumentant par un certificat bancaire de sorte que ladite somme est dès à présent à la libre disposition de la Société,
ce que le notaire instrumentant constate expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées aux articles 26, 26-3 et 26-5
de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, et en constate expressément l'accomplissement.
<i>Décisions prises par l'associé uniquei>
La partie comparante pré-qualifiée, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes
en tant qu'associé unique:
1. Le nombre d'administrateur est fixé à trois (3) et celui de commissaire à un (1).
2. M. Frederic Mireur, née le 9 janvier 1963, à Marseille, France et demeurant à Block B Riverside IV Sir John Rogerson's
Quay Dublin 2, Irlande, est nommé en qualité d'administrateur de la Société;
M. Gérard Maîtrejean, Avocat à la Cour, né le 13 juin 1967, à Charleroi, Belgique, et demeurant professionnellement
à 291, Route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, est nommé en qualité d'administrateur de la Société;
M. Frédéric Feyten, Avocat à la Cour, né le 2 juillet 1966, à Bonheiden, Belgique, et demeurant professionnellement à
291, Route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, est nommé en qualité d'administrateur de la Société;
3. Exaudit S.A., ayant son siège social à 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 124.982, est nommée en qualité de commissaire de la
Société.
4. Les mandats des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendront fin à l'issue de l'assemblée générale
ordinaire des actionnaires de 2020.
5. Le siège social de la Société est établi à L-2453 Luxembourg, rue Eugène Ruppert, 19.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui sont mis à la charge de
la Société à raison des présentes sont évalués à environ 2.300,- euros.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l'a requis
de documenter le présent procès-verbal en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire du comparant, ledit mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Hermelinski, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette, le 13 août 2014. Relation EAC / 2014/11112. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. Halsdorf.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2014130461/464.
(140148319) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2014.
137172
L
U X E M B O U R G
ECommerce Holding II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1736 Luxembourg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 177.435.
In the year two thousand and fourteen, on the twenty-eighth day of the month of July;
Before the undersigned notary Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg);
THERE APPEARED:
1. Global Fin Tech Holding S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing
under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
(Registre de Commerce et des Sociétés) under number B 184.665, having its registered office at 7, avenue J.P. Pescatore,
L-2324 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (hereinafter “Global Fin Tech Holding”),
being the holder of twelve thousand four hundred ninety-nine (12,499) common shares and five thousand two hundred
fifty (5,250) series A shares,
here represented by Mr. Luis AGUERRE ENRÍQUEZ, Doctor en Derecho, professionally residing in Luxembourg, by
virtue of a proxy, given in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 23 July 2014;
2. Bambino 53. V V UG (haftungsbeschränkt), a limited liability company (Unternehmergesellschaft (haftungsbes-
chränkt)) existing under the laws of Germany registered with the commercial register at the local court of Charlottenburg,
Germany, under no. HRB 126893 B, having its registered address at Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Germany (hereinafter
“Bambino 53. V V”),
being the holder of one (1) common share,
here represented by Mr. Luis AGUERRE ENRÍQUEZ, pre-named, by virtue of a proxy, given in Berlin, Germany, on
23 July 2014;
3. HV Holtzbrinck Ventures Fund V GmbH & Co. KG, a limited partnership (Kommanditgesellschaft) under the laws
of Germany with its statutory seat in Munich, Germany, registered with the commercial register (Handelsregister) at the
local court of Munich (Amtsgericht München), Germany, under no. HRA 98863, having its business address at Kaiserstraße
14b, 80801 Munich, Germany, represented by its general partner, HV Holtzbrinck Ventures Holding GmbH, a limited
liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) existing under the laws of Germany, registered with the com-
mercial register at the local court of Munich, Germany, under no. HRB 185098 B, having its registered address at
Kaiserstraße 14 b, 80801 Munich, Germany, (hereinafter “Holtzbrinck”),
being the holder of three thousand six hundred twenty-five (3,625) series A shares, eight hundred forty-four (844)
series B shares and eight hundred fifty-four (854) series C shares,
here represented by Mr. Luis AGUERRE ENRÍQUEZ, pre-named, by virtue of a proxy, given in Munich, Germany, on
22 July 2014;
4. AI Lendico Holdings LLC, a limited liability company under the laws of Delaware, United States of America, registered
with the Secretary of State of the state of Delaware under registration number 5482207, with its statutory seat in 2711
Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, United States of America (hereinafter “Access”),
being the holder of three thousand six hundred twenty-five (3,625) series A shares, eight hundred forty-four (844)
series B shares, and eight hundred fifty-four (854) series C shares,
here represented by Mr. Luis AGUERRE ENRÍQUEZ, pre-named, by virtue of a proxy, given in London, United King-
dom, on 23 July 2014;
5. TJT (B) (Bermuda) Investment Company Ltd., a limited liability company under the laws of Bermuda with its statutory
seat in Hamilton, Bermuda, having its business address at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, Bermuda HM11
(hereinafter, “TJT”),
being the holder of four hundred (400) series C shares,
here represented by Mr. Luis AGUERRE ENRÍQUEZ, pre-named, by virtue of a proxy, given under private seal;
6. Mr. David W. Zalaznick, born in New York, United States of America, on 16 April 1954, professionally residing in
9 West 57
th
Street - 33
rd
Floor, New York, NY 10019, USA (hereinafter “DZ”),
being the holder of four hundred (400) series C shares,
here represented by Mr. Luis AGUERRE ENRÍQUEZ, pre-named, by virtue of a proxy, given in France, on 22 July 2014;
7. Aismare Lux Holdings S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing
under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register
(Registre de Commerce et des Sociétés) under number B 176.544, having its registered office at 6C, rue Gabriel Lippmann,
L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg (hereinafter “Aismare”),
being the holder of eight hundred (800) series C shares,
here represented by Mr. Luis AGUERRE ENRÍQUEZ, pre-named, given in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
on 23 July 2014; and
137173
L
U X E M B O U R G
8. FEC Lux S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register (Registre de
Commerce et des Sociétés) under number B 173.487, having its registered office at 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (hereinafter “FEC”),
becoming the holder of one thousand nine hundred seventy-five (1,975) series C shares and participating for items 3
et seqq. of the agenda,
here represented by Mr. Luis AGUERRE ENRÍQUEZ, pre-named, by virtue of a proxy, given in Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg on 23 July 2014.
The said proxies, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary will remain annexed
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The parties listed under 1. to 7. (the “Existing Shareholders”) are all the shareholders, representing the entire share
capital of ECommerce Holding II S.à r.l. (the “Company”), a société à responsabilité limitée incorporated and existing
under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg,
Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 177.435
and incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on 7 May 2013, published in the Memorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, number 1651 dated 10 July 2013. The articles have been amended for the last time by deed
of the undersigned notary on 4 July 2014, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. The
articles of association have not been amended since.
The Existing Shareholders representing the entire share capital declare having waived any notice requirement, the
general meeting of shareholders is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the following agenda
whereby FEC participates and votes for the purpose of items 3 et seqq. of the following Agenda only:
<i>Agendai>
1. Acceptance of FEC Lux S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing
under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register
(Registre de Commerce et des Sociétés) under number B 173.487, having its registered office at 2-8, avenue Charles de
Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as new shareholder of the Company.
2. Increase of the Company’s share capital by an amount of one thousand nine hundred seventy-five euro (EUR 1,975)
so as to raise it from its current amount of twenty-nine thousand nine hundred ninety-six euro (EUR 29,996) up to thirty-
one thousand nine hundred seventy-one euro (EUR 31,971) by issuing one thousand nine hundred seventy-five (1,975)
series C shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.
3. Subsequent amendment of article 5 of the articles of association of the Company so that it shall henceforth read as
follows:
" Art. 5 Share Capital.
5.1 The Company’s share capital is set at thirty-one thousand nine hundred seventy-one euro (EUR 31,971), repre-
sented by:
5.1.1 twelve thousand five hundred (12,500) common shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each (hereinafter
“Common Shares”),
5.1.2 twelve thousand five hundred (12,500) series A shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each (hereinafter
“Series A Shares”),
5.1.3 one thousand six hundred eighty-eight (1,688) series B shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each
(hereinafter “Series B Shares”) and
5.1.4 five thousand two hundred eighty-three (5,283) series C shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each
(hereinafter “Series C Shares”, the Series A shares, the Series B Shares and the Series C Shares hereinafter also referred
to as “Preferred Shares”).
The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by these
articles of association or by the Law.
5.2 The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
5.3 Each of (i) Global Fin Tech Holding S.à. r.l. (“Rocket”), (ii) HV Holtzbrinck Ventures Fund V GmbH & Co. KG
(“Holtzbrinck”), (iii) AI Lendico Holdings LLC ("Access"), (iv) TJT (B) (Bermuda) Investment Company Ltd. (“TJT”), (v)
David W. Zalaznick (“DZ”), (vi) Aismare Lux Holdings S.à r.l. (“Aismare”) and (vii) FEC Lux S.à r.l. (“FEC”; Rocket,
Holtzbrinck, Access, TJT, DZ, Aismare and FEC jointly the “Investors” and each an “Investor”) shall be entitled to sub-
scribe for such amount of further shares to be issued in the course of a capital increase implementing an investment offer
of a third party (being neither a shareholder nor a company affiliated to a shareholder within the meaning of sections 15
et seqq. German Stock Corporation Act (AktG) (a “Third Party Investor”) and which has been approved with a majority
vote of at least seventy-five per cent (75%) of the votes of all shareholders of the Company (a “Third Party Investment”)
- irrespective whether made by the Third Party Investor or one or more matching shareholders - required to maintain
up to its percentage ownership in the Company prior to such capital increase under the same terms and conditions on
137174
L
U X E M B O U R G
which the Third Party Investment is based on. The respective Investor shall inform the Company by binding declaration
within three (3) weeks if it intends to exercise its right pursuant to the foregoing sentence of this Article 5.3”
4. Decision to amend the first paragraph of article 22.8 of the articles of association of the Company so that it shall
read as follows:
“ 22.8. The managers shall require the consent of at least two (2) of the shareholders Rocket, Holtzbrinck, Access,
TJT, DZ, Aismare and FEC which at the relevant time hold jointly more than fifty per cent (50%) of the Company’s
registered share capital (the “Investor Majority”) for the legal transactions and measures specified below. No consent is
required if such legal transactions and measures have been precisely defined and have in advance been approved by an
adopted budget with the consent of the Investor Majority:”
5. Decision to amend article 22.8.18 of the articles of association of the Company so that it shall read as follows:
“ 22.8.18. transactions of the Company and its investment companies with affiliated legal entities and individuals. As
such shall be deemed to be direct or indirect shareholders of the Company (including, for the avoidance of doubt,
European Founders Fund GmbH (“EFF”) and EFF’s direct and indirect shareholders (i.e. the Samwer brothers), but ex-
cluding any direct or indirect shareholders of Holtzbrinck and/or Access and/or TJT and/or DZ and/or Aismare and/or
FEC), affiliated companies pursuant to sections 15 et seqq. German Stock Corporation Act (AktG) as well as relatives
pursuant to section 15 German Tax Code (AO) of direct or indirect shareholders, as far as the latter (except EFF and
EFF’s direct and indirect shareholders) - individually or jointly - hold, directly or indirectly, a majority interest. The consent
requirement pursuant to this Article 22.8.18 does not apply if the transaction belongs to the ordinary course of business
of the Company and is at arm’s length;”
6. Decision to amend article 25.1 of the articles of association of the Company so that it shall read as follows:
“ 25.1. The Company shall have an advisory board. It shall consist of eight (8) voting members. The shareholders’
meeting may by way of a shareholders’ resolution increase or decrease the number of voting members of the advisory
board.”
7. Decision to amend article 25.3 of the articles of association of the Company so that it shall read as follows:
“ 25.3. The voting members of the advisory board shall be nominated, withdrawn or replaced by each member’s
respective appointing shareholder by written notification towards the Company as follows:
25.3.1 Four (4) voting members of the advisory board shall be nominated by the shareholder Rocket in its sole dis-
cretion;
25.3.2 One (1) voting member of the advisory board shall be nominated by the shareholder Holtzbrinck in its sole
discretion;
25.3.3 One (1) voting member of the advisory board shall be nominated by the shareholder Access in its sole discretion;
25.3.4 One (1) voting member of the advisory board shall be nominated by the shareholder Aismare in its sole dis-
cretion; and
25.3.5 One (1) voting member of the advisory board shall be nominated by the shareholder FEC in its sole discretion.”
Having duly considered each item of the agenda, the general meeting of shareholders unanimously takes the following
resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting of shareholders accepts FEC Lux S.à r.l. a limited liability company (société à responsabilité limitée)
incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade
and Companies’ Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under number B 173.487, having its registered office
at 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as new shareholder of the Company.
<i>Second resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves to increase the share capital of the Company by an amount of one
thousand nine hundred seventy-five euro (EUR 1,975) so as to raise it from its current amount of twenty-nine thousand
nine hundred ninety-six euro (EUR 29,996) up to thirty-one thousand nine hundred seventy-one euro (EUR 31,971) by
issuing one thousand nine hundred seventy-five (1,975) series C shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.
<i>Subscriptioni>
The one thousand nine hundred seventy-five (1,975) new series C shares have been duly subscribed by FEC Lux S.à
r.l., aforementioned, for the price of one thousand nine hundred seventy-five euro (EUR 1,975).
<i>Paymenti>
The one thousand nine hundred seventy-five (1,975) series C shares subscribed by FEC Lux S.à r.l., aforementioned,
have been entirely paid up through a contribution in cash in an amount of one thousand nine hundred seventy-five euro
(EUR 1,975).
The proof of the existence and of the value of the above contribution has been produced to the undersigned notary.
137175
L
U X E M B O U R G
The contribution in the amount of one thousand nine hundred seventy-five euro (EUR 1,975) is entirely allocated to
the share capital.
<i>Third resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves the amendment of article 5 of the articles of association of the Company
so that it shall henceforth read as follows:
" Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company’s share capital is set at thirty-one thousand nine hundred seventy-one euro (EUR 31,971), repre-
sented by:
5.1.1 twelve thousand five hundred (12,500) common shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each (hereinafter
“Common Shares”),
5.1.2 twelve thousand five hundred (12,500) series A shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each (hereinafter
“Series A Shares”),
5.1.3 one thousand six hundred eighty-eight (1,688) series B shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each
(hereinafter “Series B Shares”) and
5.1.4 five thousand two hundred eighty-three (5,283) series C shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each
(hereinafter “Series C Shares”, the Series A shares, the Series B Shares and the Series C Shares hereinafter also referred
to as “Preferred Shares”).
The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by these
articles of association or by the Law.
5.2 The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
5.3 Each of (i) Global Fin Tech Holding S.à. r.l. (“Rocket”), (ii) HV Holtzbrinck Ventures Fund V GmbH & Co. KG
(“Holtzbrinck”), (iii) AI Lendico Holdings LLC ("Access"), (iv) TJT (B) (Bermuda) Investment Company Ltd. (“TJT”), (v)
David W. Zalaznick (“DZ”), (vi) Aismare Lux Holdings S.à r.l. (“Aismare”) and (vii) FEC Lux S.à r.l. (“FEC”; Rocket,
Holtzbrinck, Access, TJT, DZ, Aismare and FEC jointly the “Investors” and each an “Investor”) shall be entitled to sub-
scribe for such amount of further shares to be issued in the course of a capital increase implementing an investment offer
of a third party (being neither a shareholder nor a company affiliated to a shareholder within the meaning of sections 15
et seqq. German Stock Corporation Act (AktG) (a “Third Party Investor”) and which has been approved with a majority
vote of at least seventy-five per cent (75%) of the votes of all shareholders of the Company (a “Third Party Investment”)
- irrespective whether made by the Third Party Investor or one or more matching shareholders - required to maintain
up to its percentage ownership in the Company prior to such capital increase under the same terms and conditions on
which the Third Party Investment is based on. The respective Investor shall inform the Company by binding declaration
within three (3) weeks if it intends to exercise its right pursuant to the foregoing sentence of this Article 5.3”
<i>Fourth resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves the amendment of article 22.8 of the articles of association of the
Company so that it shall henceforth read as follows:
“ 22.8. The managers shall require the consent of at least two (2) of the shareholders Rocket, Holtzbrinck, Access,
TJT, DZ, Aismare and FEC which at the relevant time hold jointly more than fifty per cent (50%) of the Company’s
registered share capital (the “Investor Majority”) for the legal transactions and measures specified below. No consent is
required if such legal transactions and measures have been precisely defined and have in advance been approved by an
adopted budget with the consent of the Investor Majority:”
<i>Fifth resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves the amendment of article 22.8.18 of the articles of association of the
Company so that it shall henceforth read as follows:
“ 22.8.18. transactions of the Company and its investment companies with affiliated legal entities and individuals. As
such shall be deemed to be direct or indirect shareholders of the Company (including, for the avoidance of doubt,
European Founders Fund GmbH (“EFF”) and EFF’s direct and indirect shareholders (i.e. the Samwer brothers), but ex-
cluding any direct or indirect shareholders of Holtzbrinck and/or Access and/or TJT and/or DZ and/or Aismare and/or
FEC), affiliated companies pursuant to sections 15 et seqq. German Stock Corporation Act (AktG) as well as relatives
pursuant to section 15 German Tax Code (AO) of direct or indirect shareholders, as far as the latter (except EFF and
EFF’s direct and indirect shareholders) - individually or jointly - hold, directly or indirectly, a majority interest. The consent
requirement pursuant to this Article 22.8.18 does not apply if the transaction belongs to the ordinary course of business
of the Company and is at arm’s length;”
137176
L
U X E M B O U R G
<i>Sixth resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves the amendment of article 25.1 of the articles of association of the
Company so that it shall henceforth read as follows:
“ 25.1. The Company shall have an advisory board. It shall consist of eight (8) voting members. The shareholders’
meeting may by way of a shareholders’ resolution increase or decrease the number of voting members of the advisory
board.”
<i>Seventh resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves the amendment of article 25.3 of the articles of association of the
Company so that it shall henceforth read as follows:
“ 25.3. The voting members of the advisory board shall be nominated, withdrawn or replaced by each member’s
respective appointing shareholder by written notification towards the Company as follows:
25.3.1 Four (4) voting members of the advisory board shall be nominated by the shareholder Rocket in its sole dis-
cretion;
25.3.2 One (1) voting member of the advisory board shall be nominated by the shareholder Holtzbrinck in its sole
discretion;
25.3.3 One (1) voting member of the advisory board shall be nominated by the shareholder Access in its sole discretion;
25.3.4 One (1) voting member of the advisory board shall be nominated by the shareholder Aismare in its sole dis-
cretion; and
25.3.5 One (1) voting member of the advisory board shall be nominated by the shareholder FEC in its sole discretion.”
There being no further business, the meeting is closed.
<i>Costs and expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are
estimated at approximately one thousand six hundred euro (EUR 1,600.-).
<i>Statementi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,
the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing party and
in case of divergence between the English and the German text, the English version will prevail.
WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the proxy-holder of the appearing parties, acting as said before, known to the notary
by name, first name, civil status and residence, the said proxyholder has signed with Us the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:
Im Jahre zweitausendvierzehn, am achtundzwanzigsten Tag des Monats Juli;
Vor dem unterzeichnenden Notar Carlo WERSANDT, mit Amtssitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg);
SIND ERSCHIENEN:
1. Global Fin Tech Holding S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) ge-
gründet und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und
Gesellschaftsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) unter der Nummer B 184.665, mit Sitz in 7, avenue J.P.
Pescatore, L-2324 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg („Global Fin Tech Holding“),
Inhaber von zwölftausendvierhundertneunundneunzig (12.499) Stammanteilen und fünftausendzweihundertfünfzig
(5.250) Anteilen der Serie A,
hier vertreten durch Herrn Luis AGUERRE ENRÍQUEZ, Doctor en Derecho, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß
einer Vollmacht vom 23. Juli 2014, ausgestellt in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg;
2. Bambino 53. V V UG (haftungsbeschränkt), eine Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) bestehend unter
deutschem Recht, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland, unter der Nummer
HRB 126893 B, mit Sitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Deutschland („Bambino 53. V V“),
Inhaber eines (1) Stammanteils,
hier vertreten durch Herrn Luis AGUERRE ENRÍQUEZ, vorgenannt, gemäß einer Vollmacht vom 23. Juli 2014, aus-
gestellt in Berlin, Deutschland;
3. HV Holtzbrinck Ventures Fund V GmbH & Co. KG, eine Kommanditgesellschaft nach deutschem Recht mit sat-
zungsmäßigem Sitz in München, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München, Deutschland,
unter der Nummer HRA 98863, mit Geschäftssitz in Kaiserstraße 14b, 80801 München, Deutschland, vertreten durch
ihren unbeschränkt haftenden Gesellschafter (general partner), HV Holtzbrinck Ventures Holding GmbH, eine Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung bestehend unter deutschem Recht, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts
137177
L
U X E M B O U R G
München, Deutschland, unter der Nummer HRB 185098 B, mit Sitz in Kaiserstraße 14b, 80801 München, Deutschland
(„Holtzbrinck”),
Inhaber von dreitausendsechshundertfünfundzwanzig (3.625) Anteilen der Serie A, achthundertvierundvierzig (844)
Anteilen der Serie B und achthundertvierundfünfzig (854) Anteilen der Serie C,
hier vertreten durch Herrn Luis AGUERRE ENRÍQUEZ, vorgenannt, gemäß einer Vollmacht vom 22. Juli 2014, aus-
gestellt in München, Deutschland;
4. Al Lendico Holdings LLC, eine limited liability company nach dem Recht des Bundesstaates Delaware, Vereinigte
Staaten von Amerika, eingetragen beim Secretary of State des Bundesstaates Delaware unter der Eintragungsnummer
5482207, mit satzungsmäßigem Sitz in 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, Vereinigte Staaten
von Amerika („Access“),
Inhaber von dreitausendsechshundertfünfundzwanzig (3.625) Anteilen der Serie A, achthundertvierundvierzig (844)
Anteilen der Serie B und achthundertvierundfünfzig (854) Anteilen der Serie C,
hier vertreten durch Herrn Luis AGUERRE ENRÍQUEZ, vorgenannt, gemäß einer Vollmacht vom 23. Juli 2014, aus-
gestellt in London, Vereinigtes Königreich;
5. TJT (B) (Bermuda) Investment Company Ltd., eine limited liability company nach dem Recht der Bermuda-Inseln,
mit satzungsmäßigem Sitz in Hamilton, Bermuda, mit Geschäftssitz in Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton,
Bermuda HM11 („TJT“),
Inhaber von vierhundert (400) Anteilen der Serie C,
hier vertreten durch Herrn Luis AGUERRE ENRÍQUEZ, vorgenannt, gemäß einer privatschriftlich ausgestellten Voll-
macht;
6. Herr David W. Zalaznick, geboren am 16. April 1954 in New York, Vereinigte Staaten von Amerika, geschäftsansässig
in 9 West 57
th
Street - 33
rd
Floor, New York, NY 10019, USA („DZ“),
Inhaber von vierhundert (400) Anteilen der Serie C,
hier vertreten durch Herrn Luis AGUERRE ENRÍQUEZ, vorgenannt, gemäß einer Vollmacht vom 22. Juli 2014, aus-
gestellt in Frankreich;
7. Aismare Lux Holdings S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) gegründet
und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesell-
schaftsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) unter der Nummer B 176.544, mit Sitz in 6C, rue Gabriel
Lippmann, L-5365 Munsbach, Großherzogtum Luxemburg („Aismare“),
Inhaber von achthundert (800) Anteilen der Serie C,
hier vertreten durch Herrn Luis AGUERRE ENRÍQUEZ, vorgenannt, gemäß einer Vollmacht vom 23. Juli 2014, aus-
gestellt in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg; und
8. FEC Lux S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) gegründet und beste-
hend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister
(Registre de Commerce et des Sociétés) unter der Nummer B 173.487, mit Sitz in 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653
Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg („FEC“),
zukünftiger Inhaber von eintausendneunhundertfünfundsiebzig (1.975) Anteilen der Serie C und teilnahmeberechtigt
für die Punkte 3 ff. der Tagesordnung,
hier vertreten durch Herrn Luis AGUERRE ENRÍQUEZ, vorgenannt, gemäß einer Vollmacht vom 23. Juli 2014, aus-
gestellt in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
Besagte Vollmachten, welche von dem Bevollmächtigten der erschienenen Parteien und dem Notar ne varietur para-
phiert wurden, werden der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.
Die unter Punkt 1 bis 7 aufgelisteten Parteien (die „Bestehenden Gesellschafter“) sind alle Gesellschafter und vertreten
das gesamte Gesellschaftskapital der ECommerce Holding II S.à r.l. (die „Gesellschaft”), einer Gesellschaft mit beschränk-
ter Haftung (société à responsabilité limitée), gegründet und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxem-
burg, mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels-
und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 177.435, gegründet am 7. Mai 2013 gemäß einer Urkunde des
unterzeichnenden Notars, welche am 10. Juli 2013 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1651,
veröffentlicht wurde. Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt am 4. Juli 2014 gemäß einer Urkunde des unterzeichn-
enden Notars geändert, welche noch nicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht wurde.
Die Satzung der Gesellschaft wurde seitdem nicht geändert.
Da die Bestehenden Gesellschafter das gesamte Gesellschaftskapital vertreten und erklären, auf jegliche Ladungsfor-
malitäten verzichtet zu haben, ist die Gesellschafterversammlung ordnungsgemäß zusammengekommen und kann wirksam
über alle Punkte der folgenden Tagesordnung verhandeln, wobei FEC ausschließlich für die Punkte 3 ff. der folgenden
Tagesordnung teilnahme- und stimmberechtigt ist:
137178
L
U X E M B O U R G
<i>Tagesordnungi>
1. Aufnahme von FEC Lux S.à r.l., einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) ge-
gründet und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und
Gesellschaftsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) unter der Nummer B 173.487, mit Sitz in 2-8, avenue
Charles de Gaulle, L-1653 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, als neuer Gesellschafter der Gesellschaft.
2. Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von neunundzwanzigtausend-
neunhundertsechsundneunzig Euro (EUR 29.996) um einen Betrag von eintausendneunhundertfünfundsiebzig Euro (EUR
1.975) auf einen Betrag von einunddreißigtausendneunhunderteinundsiebzig Euro (EUR 31.971) durch die Ausgabe von
eintausendneunhundertfünfundsiebzig (1.975) Anteilen der Serie C mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1).
3. Dementsprechende Änderung des Artikels 5 der Satzung der Gesellschaft, welcher nunmehr wie folgt lautet:
„ Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt einunddreißigtausendneunhunderteinundsiebzig Euro (EUR
31.971), bestehend aus:
5.1.1 zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteilen mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1) (die
„Stammanteile”),
5.1.2 zwölftausendfünfhundert (12.500) Anteilen der Serie A mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1) (die
„Anteile der Serie A”),
5.1.3 eintausendsechshundertachtundachtzig (1.688) Anteilen der Serie B mit einem Nominalwert von je einem Euro
(EUR 1) (die „Anteile der Serie B”) und
5.1.4 fünftausendzweihundertdreiundachtzig (5.283) Anteilen der Serie C mit einem Nominalwert von je einem Euro
(EUR 1) (die „Anteile der Serie C“, wobei die Anteile der Serie A, die Anteile der Serie B und die Anteile der Serie C im
Folgenden auch als „Vorzugsanteile“ bezeichnet werden).
Die mit den Anteilen verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es wird in dieser Satzung oder
durch das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.
5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-
zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.
5.3 (i) Global Fin Tech Holding S.à r.l. („Rocket“), (ii) HV Holtzbrinck Ventures Fund V GmbH & Co. KG („Holtz-
brinck“), (iii) Al Lendico Holdings LLC („Access“), (iv) TJT (B) (Bermuda) Investment Company Ltd. („TJT”), (v) David
W. Zalaznick („DZ“), (vi) Aismare Lux Holdings S.à r.l. („Aismare“) und (vii) FEC Lux S.à r.l. („FEC“; Rocket, Holtzbrinck,
Access, TJT, DZ, Aismare und FEC gemeinschaftlich die „Investoren“ und jeweils ein „Investor“) ist jeweils zur Zeichnung
einer Anzahl weiterer bei einer Kapitalerhöhung ausgegebener Anteile berechtigt, wodurch ein Investmentangebot eines
Dritten umgesetzt wird (bei dem es sich weder um einen Gesellschafter, noch um eine mit einem Gesellschafter ver-
bundene Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG) (ein „Drittinvestor“) handelt), der mit
einer Mehrheit von mindestens fünfundsiebzig Prozent (75%) der Stimmen aller Gesellschafter der Gesellschaft zuge-
stimmt wurde (eine „Investition eines Dritten“) -unabhängig davon, ob diese vom Drittinvestor oder von einem oder
mehreren vergleichbaren Gesellschaftern erfolgte - und die zur Erhaltung der Beteiligungsquote an der Gesellschaft vor
einer solchen Kapitalerhöhung erforderlich ist, und dies zu denselben Bedingungen, wie bei einer Investition eines Dritten.
Der jeweilige Investor hat die Gesellschaft durch eine verbindliche Erklärung innerhalb von drei (3) Wochen darüber zu
unterrichten, ob er sein Recht gemäß des vorstehenden Satzes dieses Artikels 5.3 ausüben möchte.“
4. Beschluss bezüglich der Änderung des ersten Paragraphen des Artikels 22.8 der Satzung der Gesellschaft, welcher
wie folgt lautet:
„ 22.8. Die Geschäftsführer benötigen die Zustimmung von mindestens zwei (2) der Gesellschafter Rocket, Holtz-
brinck, Access, TJT, DZ, Aismare und FEC, die zum gegebenen Zeitpunkt gemeinsam mehr als fünfzig Prozent (50%) des
eingetragenen Gesellschaftskapitals der Gesellschaft halten (die „Mehrheit der Investoren“) für die unten aufgeführten
Rechtsgeschäfte und Maßnahmen. Eine Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn solche Rechtsgeschäfte und Maßnahmen
präzise definiert und im Voraus von einem bewilligten Haushaltsplan mit der Zustimmung der Mehrheit der Investoren
genehmigt wurden:“
5. Beschluss bezüglich der Änderung des Artikels 22.8.18 der Satzung der Gesellschaft, welcher wie folgt lautet:
„ 22.8.18. Transaktionen der Gesellschaft und ihrer Investoren mit verbundenen juristischen und natürlichen Personen.
Als solche werden angesehen direkte oder indirekte Gesellschafter der Gesellschaft (einschließlich, zur Klarstellung,
European Founders Fund GmbH („EFF“) und EFF’s direkte und indirekte Gesellschafter (z.B. die Samwer Brüder), aber
ausschließlich direkter oder indirekter Gesellschafter von Holtzbrinck und/oder Access und/oder TJT und/oder DZ und/
oder Aismare und/oder FEC), verbundene Gesellschaften gemäß §§ 15 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG), sowie
Angehörige direkter oder indirekter Gesellschafter gemäß Abschnitt 15 der deutschen Abgabenordnung (AO), sofern
letztere (mit Ausnahme von EFF und EFF’s direkter und indirekter Gesellschafter) - einzeln oder gemeinsam - direkt oder
indirekt eine Mehrheitsbeteiligung halten. Die Zustimmung gemäß dieses Artikels 22.8.18 ist nicht erforderlich, wenn die
Transaktion zum gewöhnlichen Geschäftsgang der Gesellschaft gehört und marktüblichen Bedingungen unterliegt;“
6. Beschluss bezüglich der Änderung des Artikels 25.1 der Satzung der Gesellschaft, welcher wie folgt lautet:
137179
L
U X E M B O U R G
„ 25.1. Die Gesellschaft hat einen Beirat. Dieser besteht aus acht (8) stimmberechtigten Mitgliedern. Die Gesellschaf-
terversammlung kann durch einen Gesellschafterbeschluss die Anzahl der stimmberechtigten Mitglieder des Beirats
erhöhen oder herabsetzen.“
7. Beschluss bezüglich der Änderung des Artikels 25.3 der Satzung der Gesellschaft, welcher wie folgt lautet:
„ 25.3. Die stimmberechtigten Mitglieder des Beirats werden von dem entsprechenden ernennenden Gesellschafter
jedes Mitglieds durch schriftliche Mitteilung an die Gesellschaft wie folgt ernannt, abberufen oder ersetzt:
25.3.1 Vier (4) stimmberechtigte Mitglieder des Beirats werden von dem Gesellschafter Rocket nach eigenem Ermessen
ernannt;
25.3.2 Ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats wird von dem Gesellschafter Holtzbrinck nach eigenem Ermessen
ernannt;
25.3.3 Ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats wird von dem Gesellschafter Access nach eigenem Ermessen
ernannt;
25.3.4 Ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats wird von dem Gesellschafter Aismare nach eigenem Ermessen
ernannt; und 25.3.5 Ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats wird von dem Gesellschafter FEC nach eigenem Er-
messen ernannt.“ Nach ordnungsgemäßer Prüfung jedes Tagesordnungspunkts fasst die Gesellschafterversammlung
einstimmig die folgenden Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung nimmt FEC Lux S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à respon-
sabilité limitée) gegründet und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, eingetragen im Luxemburger
Handelsund Gesellschaftsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) unter der Nummer B 173.487, mit Sitz in 2-8,
avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, als neuen Gesellschafter der Gesellschaft an.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt, das Gesellschaftskapital der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von
neunundzwanzigtausendneunhundertsechsundneunzig Euro (EUR 29.996) um einen Betrag von eintausendneunhundert-
fünfundsiebzig Euro (EUR 1.975) auf einen Betrag von einunddreißigtausendneunhunderteinundsiebzig Euro (EUR 31.971)
durch die Ausgabe von tausendneunhundertfünfundsiebzig (1.975) Anteilen der Serie C mit einem Nominalwert von je
einem Euro (EUR 1), zu erhöhen.
<i>Zeichnungi>
Die tausendneunhundertfünfundsiebzig (1.975) Anteile der Serie C wurden ordnungsgemäß durch FEC Lux S.à r.l.,
vorbenannt, zum Preis von tausendneunhundertfünfundsiebzig Euro (EUR 1.975) gezeichnet.
<i>Zahlungi>
Die von FEC Lux S.à r.l., vorbenannt, gezeichneten tausendneunhundertfünfundsiebzig (1.975) Anteile der Serie C
wurden vollständig eingezahlt durch eine Bareinlage in Höhe von tausendneunhundertfünfundsiebzig Euro (EUR 1.975).
Der Nachweis über die Existenz und den Wert der oben bezeichneten Einlage wurde dem unterzeichnenden Notar
erbracht.
Die Einlage in Höhe von tausendneunhundertfünfundsiebzig Euro (EUR 1.975) wird vollständig dem Gesellschaftskapital
zugeführt.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt, Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft zu ändern, welcher nunmehr wie
folgt lautet:
„ Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt einunddreißigtausendneunhunderteinundsiebzig Euro (EUR
31.971), bestehend aus:
5.1.1 zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteilen mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1) (die
„Stammanteile”),
5.1.2 zwölftausendfünfhundert (12.500) Anteilen der Serie A mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1) (die
„Anteile der Serie A”),
5.1.3 eintausendsechshundertachtundachtzig (1.688) Anteilen der Serie B mit einem Nominalwert von je einem Euro
(EUR 1) (die „Anteile der Serie B”) und
5.1.4 fünftausendzweihundertdreiundachtzig (5.283) Anteilen der Serie C mit einem Nominalwert von je einem Euro
(EUR 1) (die „Anteile der Serie C“, wobei die Anteile der Serie A, die Anteile der Serie B und die Anteile der Serie C im
Folgenden auch als „Vorzugsanteile“ bezeichnet werden).
Die mit den Anteilen verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es wird in dieser Satzung oder
durch das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.
137180
L
U X E M B O U R G
5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-
zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.
5.3 (i) Global Fin Tech Holding S.à r.l. („Rocket“), (ii) HV Holtzbrinck Ventures Fund V GmbH & Co. KG („Holtz-
brinck“), (iii) Al Lendico Holdings LLC („Access“), (iv) TJT (B) (Bermuda) Investment Company Ltd. („TJT”), (v) David
W. Zalaznick („DZ“), (vi) Aismare Lux Holdings S.à r.l. („Aismare“) und (vii) FEC Lux S.à r.l. („FEC“; Rocket, Holtzbrinck,
Access, TJT, DZ, Aismare und FEC gemeinschaftlich die „Investoren“ und jeweils ein „Investor“) ist jeweils zur Zeichnung
einer Anzahl weiterer bei einer Kapitalerhöhung ausgegebener Anteile berechtigt, wodurch ein Investmentangebot eines
Dritten umgesetzt wird (bei dem es sich weder um einen Gesellschafter, noch um eine mit einem Gesellschafter ver-
bundene Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG) (ein „Drittinvestor“) handelt), der mit
einer Mehrheit von mindestens fünfundsiebzig Prozent (75%) der Stimmen aller Gesellschafter der Gesellschaft zuge-
stimmt wurde (eine „Investition eines Dritten“) -unabhängig davon, ob diese vom Drittinvestor oder von einem oder
mehreren vergleichbaren Gesellschaftern erfolgte - und die zur Erhaltung der Beteiligungsquote an der Gesellschaft vor
einer solchen Kapitalerhöhung erforderlich ist, und dies zu denselben Bedingungen, wie bei einer Investition eines Dritten.
Der jeweilige Investor hat die Gesellschaft durch eine verbindliche Erklärung innerhalb von drei (3) Wochen darüber zu
unterrichten, ob er sein Recht gemäß des vorstehenden Satzes dieses Artikels 5.3 ausüben möchte.“
<i>Vierter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt, Artikel 22.8 der Satzung der Gesellschaft zu ändern, welcher nunmehr wie
folgt lautet:
„ 22.8. Die Geschäftsführer benötigen die Zustimmung von mindestens zwei (2) der Gesellschafter Rocket, Holtz-
brinck, Access, TJT, DZ, Aismare und FEC, die zum gegebenen Zeitpunkt gemeinsam mehr als fünfzig Prozent (50%) des
eingetragenen Gesellschaftskapitals der Gesellschaft halten (die „Mehrheit der Investoren“) für die unten aufgeführten
Rechtsgeschäfte und Maßnahmen. Eine Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn solche Rechtsgeschäfte und Maßnahmen
präzise definiert und im Voraus von einem bewilligten Haushaltsplan mit der Zustimmung der Mehrheit der Investoren
genehmigt wurden:“
<i>Fünfter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt, Artikel 22.8.18 der Satzung der Gesellschaft zu ändern, welcher nunmehr
wie folgt lautet:
„ 22.8.18. Transaktionen der Gesellschaft und ihrer Investoren mit verbundenen juristischen und natürlichen Personen.
Als solche werden angesehen direkte oder indirekte Gesellschafter der Gesellschaft (einschließlich, zur Klarstellung,
European Founders Fund GmbH („EFF“) und EFF’s direkte und indirekte Gesellschafter (z.B. die Samwer Brüder), aber
ausschließlich direkter oder indirekter Gesellschafter von Holtzbrinck und/oder Access und/oder TJT und/oder DZ und/
oder Aismare und/oder FEC), verbundene Gesellschaften gemäß §§ 15 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG), sowie
Angehörige direkter oder indirekter Gesellschafter gemäß Abschnitt 15 der deutschen Abgabenordnung (AO), sofern
letztere (mit Ausnahme von EFF und EFF’s direkter und indirekter Gesellschafter) - einzeln oder gemeinsam - direkt oder
indirekt eine Mehrheitsbeteiligung halten. Die Zustimmung gemäß dieses Artikels 22.8.18 ist nicht erforderlich, wenn die
Transaktion zum gewöhnlichen Geschäftsgang der Gesellschaft gehört und marktüblichen Bedingungen unterliegt;“
<i>Sechster Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt, Artikel 25.1 der Satzung der Gesellschaft zu ändern, welcher nunmehr wie
folgt lautet:
„ 25.1. Die Gesellschaft hat einen Beirat. Dieser besteht aus acht (8) stimmberechtigten Mitgliedern. Die Gesellschaf-
terversammlung kann durch einen Gesellschafterbeschluss die Anzahl der stimmberechtigten Mitglieder des Beirats
erhöhen oder herabsetzen.“
<i>Siebter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt, Artikel 25.3 der Satzung der Gesellschaft zu ändern, welcher nunmehr wie
folgt lautet:
„ 25.3. Die stimmberechtigten Mitglieder des Beirats werden von dem entsprechenden ernennenden Gesellschafter
jedes Mitglieds durch schriftliche Mitteilung an die Gesellschaft wie folgt ernannt, abberufen oder ersetzt:
25.3.1 Vier (4) stimmberechtigte Mitglieder des Beirats werden von dem Gesellschafter Rocket nach eigenem Ermessen
ernannt;
25.3.2 Ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats wird von dem Gesellschafter Holtzbrinck nach eigenem Ermessen
ernannt;
25.3.3 Ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats wird von dem Gesellschafter Access nach eigenem Ermessen
ernannt;
137181
L
U X E M B O U R G
25.3.4 Ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats wird von dem Gesellschafter Aismare nach eigenem Ermessen
ernannt; und 25.3.5 Ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats wird von dem Gesellschafter FEC nach eigenem Er-
messen ernannt.“
Da die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung geschlossen.
<i>Kosten und Auslageni>
Die Kosten, Auslagen, Honorare und Gebühren jeglicher Art, die von der Gesellschaft zu tragen sind, werden auf
ungefähr tausendsechshundert Euro (EUR 1.600,-) geschätzt.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache beherrscht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende
Urkunde auf Verlangen der erschienenen Parteien auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung;
auf Verlangen besagter erschienener Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen
Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.
WORÜBER die vorliegende notarielle Urkunde in Luxembourg, an dem oben angegebenen Tag, erstellt wurde.
Nach Vorlesung der vorliegenden Urkunde an den Bevollmächtigten der erschienenen Parteien, handelnd wie zuvor
erwähnt, dem Notar mit Vor- und Zunamen, Personenstand und Wohnort bekannt, hat besagte Bevollmächtigte mit Uns,
dem Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Signé: L. AGUERRE ENRÍQUEZ, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 31 juillet 2014. LAC/2014/36296. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Irène Thill.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Luxembourg, le 12 août 2014.
Référence de publication: 2014130606/518.
(140148273) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2014.
European Commodity Company S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 184.791.
In the year two thousand fourteen, on the fourth of August,
Before Maître Joseph ELVINGER, Civil Law Notary, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersi-
gned.
There appeared:
Sara Lecomte, private employee, professionally residing in Luxembourg (hereinafter referred to as the “proxy holder”);
acting in her capacity as a special proxy holder of the Board of Directors of the Société Anonyme “European Com-
modity Company S.A.”, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under section B number
1844791, having its registered office at 29, avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg incorporated pursuant to a
notarial deed enacted by Maître Martine SCHAEFFER, Civil Law Notary, residing in Luxembourg, acting instead and place
of Maître Joseph ELVINGER, Civil Law Notary in Luxembourg, temporarily unavailable on 13 February 2014, published
in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (hereinafter referred to as the “Mémorial C”) number
1138 on 6 May 2014; the Articles of Association of which have been amended for the last time pursuant to a notarial
deed enacted by Maître Martine SCHAEFFER, Civil Law Notary, residing in Luxembourg, acting instead and place of Maître
Joseph ELVINGER, Civil Law Notary in Luxembourg, temporarily unavailable on 7 March 2014 published in the Mémorial
C number 1288 on 20 May 2014.
by virtue of the authority conferred on her by decisions of the Board of Directors taken on the occasion of its meeting
held on 9 July 2014;
an copy of the minutes of the said meeting, signed ne varietur by the appearing person and the notary, shall remain
attached to the present deed to be filed together with it.
The said appearing person, acting in her said capacity, has requested the attesting notary public to record her decla-
rations and statements which follow:
I.- That the subscribed share capital of the prenamed Société Anonyme “European Commodity Company S.A.”,
amounts currently to fifty thousand US Dollars (USD 50,000.-), represented by five million (5,000,000) ordinary shares
with a nominal value of one cent (USD 0.01) each; all subscribed and fully paid up.
II.- That on terms of article 5.3 of the articles of association, the authorized capital has been set at twenty million US
Dollars (USD 20,000,000.-) divided into two billion (2,000,000,000) ordinary shares, having a par value of one cent (USD
0.01) each and the Board of Directors has been authorized for a period of five (5) years starting from the date of publication
137182
L
U X E M B O U R G
in the Mémorial C of the incorporation deed of the Company dated 13 February 2014 i.e. 6 May 2014 to increase the
capital of the Company within that limit and without reserving for the current shareholders of the company a preferential
right to subscribe.
III.- That the Board of Directors, in its meeting held on 9 July 2014 and in accordance with the authorities conferred
on it by the terms of article five of the articles of association, has realized an increase of capital by the amount of nine
hundred thousand US Dollars (USD 900,000.-) so as to raise the subscribed capital from its present amount of fifty
thousand US Dollars (USD 50,000.-) up to nine hundred fifty thousand (USD 950,000.-) by the creation and issue of ninety
million (90,000,000) new ordinary shares with a par value of one cent (USD 0.01) each, having the same rights and privileges
as the existing shares.
IV.- That still pursuant to the powers conferred to the Board of Directors, on terms of Article 5.3 of the articles of
association, the Board has allowed to the subscription of the total new shares by the sole shareholder of the Company.
V.- That the ninety million (90,000,000) new ordinary shares have been entirely subscribed and fully paid up by con-
tribution in cash credited of the bank account of the company prenamed, so that the amount of nine hundred thousand
US Dollars (USD 900,000.-) has been at the free disposal of the said company; evidence of such contribution has certified
to the attesting notary by production of the support documentation related to the subscription and payment.
VI.- That following the realization of this authorized increase of the share capital, article 5.1 of the articles of association
has therefore been amended as follows:
" 5. Capital.
5.1. The share capital of the Company is set nine hundred fifty thousand (USD 950,000.-) represented by ninety five
million (95,000,000) ordinary shares, having a par value of one cent (USD 0.01) each, all subscribed and fully paid-up."
<i>Expensesi>
The expenses, incumbent on the company and charged to it by reason of the present deed, are estimated at approxi-
mately two thousand euros (EUR 2,000.-).
<i>Prevailing languagei>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of discrepancy between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, the said person signed together with Us, the notary, the
present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille quatorze, le quatre août,
Par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
A COMPARU:
Sara Lecomte, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg (ci-après le «mandataire»),
agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d'administration de la société anonyme «European Commodity
Company S.A.», ayant son siège social au 29, avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous section B numéro 184791, constituée suivant Maître Martine
SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Joseph ELVINGER, notaire de
résidence à Luxembourg, momentanément empêché, en date du 13 février 2014, publié au Mémorial C, Recueil Spécial
des Sociétés et Associations (ci-après le «Mémorial C») numéro 1138 du 6 mai 2014; et dont les statuts ont été modifiés
pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en
remplacement de Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément empêché, en date du
7 mars 2014 publié au Mémorial C numéro 1288 du 20 mai 2014,
en vertu d'un pouvoir lui-conféré par décisions du conseil d'administration prises en sa réunion du 9 juillet 2014; une
copie du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte avec lequel il sera formalisé.
Lequel mandataire, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses dé-
clarations et constatations:
I.- Que le capital social de la société anonyme «European Commodity Company S.A.», prédésignée, s'élève actuelle-
ment à cinquante mille Dollars US (USD 50.000,-) représenté par cinq millions (5.000.000) d’actions ordinaires d’une
valeur nominale d’un cent (USD 0,01) chacune; entièrement souscrites et libérées.
II.- Qu'aux termes de l’article 5.3 des statuts, le capital autorisé de la société a été fixé à deux millions de Dollars US
(USD 2.000.000,-) représenté par deux milliards (2.000.000.000) d’actions ordinaires d’une valeur nominale d’un cent
(USD 0,01) chacune; et le conseil d'administration a été autorisé à décider pour une période de cinq (5) ans commençant
137183
L
U X E M B O U R G
à la date de publication au Mémorial C de l’acte de constitution de la société daté du 13 février 2014, soit le 13 mai 2014,
de procéder à la réalisation de l’augmentation du capital de la société dans cette limite et sans réserver de droit préférentiel
de souscription aux actuels actionnaires de la société;
III.- Que le conseil d'administration, en sa réunion du 9 juillet 2014 et en conformité des pouvoirs à lui conférés aux
termes de l’article 5.3 des statuts, a réalisé une augmentation du capital social dans les limites du capital autorisé à
concurrence de neuf cent mille Dollars US (USD 900.000,-) en vue de porter le capital social souscrit de son montant
actuel de cinquante mille Dollars (USD 50.000,-) à neuf cent cinquante mille Dollars US (USD 950.000,-), par la création
et l’émission de quatre-vingt-dix millions (90.000.000) d’actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale d’un cent
(USD 0,01) chacune, à souscrire et à libérer intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que
les actions existantes.
IV.- Que le conseil d'administration, a accepté la souscription de la totalité des actions nouvelles par l’actionnaire
unique de la société.
V.- Que les quatre-vingt-dix millions (90.000.000) d’actions ordinaires nouvelles ont été souscrites par le souscripteur
prédésigné et libérées intégralement en numéraire par versement sur un compte bancaire au nom de la société prédé-
signée, de sorte que la somme de neuf cent mille Dollars US (USD 900.000,-) a été mise à la libre disposition de cette
dernière; ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par la présentation des pièces justificatives des souscription et
libération.
VI.- Que suite à la réalisation de cette augmentation dans les limites du capital autorisé l’article 5.1 des statuts est
modifié en conséquence et a désormais la teneur suivante:
« 5. Capital social.
5.1. Le capital social de la Société est fixé à neuf cent cinquante mille Dollars US (USD 950.000,-), représenté par
quatre-vingt-quinze millions (95.000.000) d’actions ordinaires, ayant une valeur nominale d’un cent (USD 0,01) chacune,
toutes souscrites et entièrement libérées.»
<i>Frais et dépensi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de deux mille euros (EUR 2.000,-).
<i>Version prépondérantei>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes com-
parantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française, à la requête des mêmes personnes et
en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: S. LECOMTE, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils le 7 août 2014. Relation: LAC/2014/37520. Reçu soixante-quinze euros (EUR
75,-).
<i>Le Receveuri>
(signé): C. FRISING.
Référence de publication: 2014130601/125.
(140148406) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2014.
Levanna Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 123.541.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
LEVANNA SICAV
Société Européenne de Banque
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
Référence de publication: 2014129568/14.
(140146968) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2014.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
137184
Actimalux S.A.
Aerium H2O S.à r.l.
Agenor S.A. SPF
Ahlers International S.A.
Alpha Wealth Management Luxembourg
Apolux S.A.
Ares Capital Europe II Holdings S.à r.l.
Arsemia
Arulux First S.à r.l.
Aspen FinanceCo S.à r.l.
Attila S.A.
Awas Luxembourg 6220 S.A.
Baluardo Funding S.à r.l.
B & B Investments S.A.
Becos S.à r.l.
Benaruca S.A.
Best Services S.A.
B&W NE Luxembourg
Capitaux d'Investissements et de Résultats S.A.
Centaur Luxco S.à r.l.
CEREP Italy One S.à r.l.
Circeo S.A.
Citra S.à r.l.
Clearsight Holdings (Luxembourg) S.à r.l.
CN Air S.à r.l.
ColorPortal Europe S.A.
DAIWA SBI Lux Funds SICAV
D'Amici S.à.r.l.
Depalom S.A.
Die Heimkinoschmiede S.à r.l.
Dinavest
ECommerce Holding II S.à r.l.
Eralda International, S.à r.l.
European Commodity Company S.A.
Europrovincial Properties S.à r.l.
Evergreen Investments S.A.
Food Service Group S.A.
Highstreet Propco III S.à r.l.
Immobilière du X septembre S.A.
IT Investments S.à r.l.
Levanna Sicav
Louis Vuitton Luxembourg S.à r.l.
Luxe Drive S.L. S.à r.l.
LUXIMMO Achte Beteiligungsgesellschaft AG
Luxroyal Management S.A.
Magequam
Mandarina Real Estate S.à r.l.
Master 6
Muirfield Investments S.à r.l.
Partners Group Global Infrastructure SICAV
Savoia S.à.r.l.
Tenotel
Te Ora S.A.
UBS (Lux) Sicav 2