logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2817

9 octobre 2014

SOMMAIRE

Aerlux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135177

ALG Luxco S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135180

Alistair Investissement S.A.  . . . . . . . . . . . . .

135174

Altor CIB Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

135176

Beim Engelchen S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

135207

Bull & Bear Finance S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

135208

CCI Participations SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135175

Chazur Property S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135176

ContourGlobal Africa Holdings S.à r.l.  . . .

135179

Demessy Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

135174

Essonne S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135177

Filmod International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

135178

FINIMPEX S.A., société de gestion de pa-

trimoine familial  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135197

Galor Holding S.A. SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . .

135172

Ganges Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

135174

Heitman UCITS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135180

Helvetia Capital Holding S.A.  . . . . . . . . . . .

135198

Highstreet Propco II s.à R.L.  . . . . . . . . . . . .

135208

Ideal Standard International S.A.  . . . . . . . .

135204

Immobilière Saint Marcel S.A.  . . . . . . . . . .

135211

Immoparko S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135212

Interactive Creatures Environment Limi-

ted S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135213

Invensys European Holdings S.à r.l.  . . . . . .

135214

Laboratoires Pharmedical S.A.  . . . . . . . . . .

135170

Loquacious S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135170

Manulife Global Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135195

Olin Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135175

Optimal Diversified Portfolio . . . . . . . . . . . .

135170

PHV. s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135205

Pioneer Investments Guaranteed Funds

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135172

Presence Communication  . . . . . . . . . . . . . .

135172

President B  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135177

Promox S.A. - SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135178

Pro-Vision BRD S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135200

Pro-Vision S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135200

Renson & Associates Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . .

135197

Renson & Associates Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . .

135204

Rhombus Ten S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135216

Rive Private Investment  . . . . . . . . . . . . . . . .

135200

SAB, G.m.b.H.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135202

Simak Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135216

Sixth Dimension S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135206

Sobel Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

135216

Société Générale Private Wealth Manage-

ment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135196

Sources & Trades Technology Services S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135206

SPL S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135202

Suisimmo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135173

Sustainable Assets No. 2  . . . . . . . . . . . . . . . .

135200

Thebes Capital Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . .

135198

The Turquoise II Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135171

Thunder Holding S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . .

135173

Titlis S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135176

TRIWO Technopark Aachen Develop-

ment S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135197

Twin Holding 1 S.à.r.l . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135173

Valauchanrus Sopaneer S.C.A.  . . . . . . . . . .

135179

Valauchan Sopaneer International S.C.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135178

VC Holding II S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135173

135169

L

U X E M B O U R G

Optimal Diversified Portfolio, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R.C.S. Luxembourg B 70.595.

Par le présent avis, les actionnaires sont conviés à assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

de Optimal Diversified Portfolio, qui se tiendra dans les locaux de ING Investment Management Luxembourg au 3 rue

Jean Piret, L-2350 Luxembourg, le <i>27 octobre 2014 à 11h00, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises
2. Approbation des comptes au 30 juin 2014
3. Affectation des résultats
4. Décharge aux administrateurs
5. Nominations statutaires (démission(s) et/ou nomination(s))
Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à la condition d'avoir cinq jours francs au moins

avant la réunion, fait connaître au Conseil d'Administration leur intention de prendre part à l'assemblée.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014156875/755/19.

Laboratoires Pharmedical S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 8.201.

Messrs. shareholders are hereby convened to attend the

GENERAL MEETING

which is going to be held extraordinarily at the address of the registered office, on <i>10 November 2014 at 17.00 o'clock,

with the following agenda:

<i>Agenda:

• "Resolution to be taken according to article 100 of the law of 10 August 1915."

The statutory general meeting held extraordinarily on 2 October 2014 was not able to deliberate on the item 3, as

the legally required quorum was not achieved. The general meeting, which is going to be held extraordinarily on 10
November will deliberate whatever the proportion of the capital represented.

<i>The board of directors.

Référence de publication: 2014156838/534/16.

Loquacious S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 44, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 179.759.

Le Conseil d'Administration à l'honneur de convoquer les Actionnaires à assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des Actionnaires qui se tiendra de façon exceptionnelle en date du <i>27 octobre 2014 à 14.00 heures au siège social avec

l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Constatation et approbation du report de la date de l'Assemblée Générale Ordinaire ayant pour objet l'approbation

des comptes annuels clôturés au 31 mars 2014.

2. Présentation et approbation du rapport de contrôle du Commissaire relatif à l'exercice clôturé au 31 mars 2014.
3. Approbation du bilan arrêté au 31 mars 2014 et du compte de profits et pertes y relatif; affectation des résultats.
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire pour l'exercice de leur fonction durant l'exercice clôturé au 31

mars 2014.

5. Divers.

<i>Pour le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014151845/19.

135170

L

U X E M B O U R G

The Turquoise II Fund, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1160 Luxembourg, 16, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 135.452.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-second day of the month of September,
Before Us Maître Cosita DELVAUX, notary residing in Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg,

Was held

an extraordinary general meeting of shareholders (the "Meeting") of THE TURQUOISE II FUND (hereafter referred

to as the "Fund"), a société d'investissement à capital variable having its registered office in L-1160 Luxembourg, 16,
boulevard d'Avranches (R.C.S. Luxembourg B 135.452) incorporated pursuant to a notarial deed of Maître Joseph Elvinger,
notary residing in Luxembourg, on 21 December 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
(the "Mémorial"), number 264 on 1 February 2008.

The Meeting was presided by Mrs Géraldine Astgen, professionally residing in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Mrs Maryse Duffin, professionally residing in Luxembourg.
The Meeting elected as scrutineer Mrs Valérie Steffanus, professionally residing in Luxembourg.
The bureau of the Meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the Meeting is the following:
1. To resolve upon the liquidation of the Fund.
2. To appoint PricewaterhouseCoopers represented by Mrs Anne Laurent as liquidator of the Fund (the “Liquidator”)

and to determine the Liquidator's powers and remuneration.

II. The Meeting was duly convened by notices containing the agenda sent on 9 September 2014 to all the shareholders

by registered mail.

III. The shareholders present or represented, and the number of their shares are shown on an attendance list; that

attendance list, after having been signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary, will
remain annexed to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders initialled “ne varietur” by the appearing parties will also remain annexed

to this deed.

IV. It appears from the attendance list that at least 50% of the Fund's capital is present or represented at the Meeting.
V. As a result of the foregoing, the Meeting is regularly constituted and may validly deliberate and vote on the items

of the agenda.

Then the Meeting, after deliberation, takes the following resolutions:

<i>First resolution

The Meeting unanimously decides to put the Fund into liquidation with immediate effect.

<i>Second resolution

The Meeting unanimously appoints as the liquidator of the Fund: PricewaterhouseCoopers, having its registered office

in L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch, represented by Mrs Anne Laurent.

The Liquidator is granted the most general powers provided for by articles 144 to 148bis of the amended law of 10

August 1915 on commercial companies (the "Law"). The Liquidator will be entitled to take all action provided by article
145 of the Law without authorisation of the general meeting of shareholders in the situations where this authorisation
would be required.

The Liquidator is entitled to relieve the registrar of the office of mortgages of the charge to register liens and prefe-

rential rights; renounce all rights in rem, preferential rights, privileges, mortgages and cancellation clauses, consent release
and clearance, with or without payment, of all preferential rights and mortgages, transcriptions, attachments, seizures or
other encumbrances.

The Liquidator is not required to draw up any inventory and may rely on the accounts of the Fund.
The Liquidator is authorised, under his responsibility, to delegate, with regard to special and determined operations,

to one or more proxyholders, such part of his authorities and for such duration as he may determine.

The Liquidator shall be entitled to remuneration in accordance with market practice applicable to services rendered

by chartered accountants.

Following the passing of the above resolutions, the Meeting acknowledges that the audit of the liquidation accounts

will be made by the approved statutory auditor of the Fund.

There being no further business on the agenda, the Meeting is thereupon closed.

Whereupon, this deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

135171

L

U X E M B O U R G

The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that this deed is, on request of the

appearing person, worded in English only.

The document having been read to the persons appearing all known by the notary by their names, first names, civil

status and residences, the members of the board signed together with the notary this deed.

Signé: G. ASTGEN, M. DUFFIN, V. STEFFANUS, C. DELVAUX.
Enregistré à Redange/Attert, le 26 septembre 2014. Relation: RED/2014/2115. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): T. KIRSCH.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Redange-sur-Attert, le 26 septembre 2014.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2014153192/66.
(140174597) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2014.

Pioneer Investments Guaranteed Funds, Fonds Commun de Placement.

WKN: A0Q5EL - ISIN: LU0364956697

Der Teilfonds Pioneer Guaranteed September 2014 wurde zum 30.09.2014 liquidiert und der Fonds Pioneer Invest-

ments Guaranteed Funds von der offiziellen Liste für Organismen für gemeinsame Anlagen gestrichen.

Die Liquidation ist abgeschlossen, alle Investoren wurden ausbezahlt. Es wurden keine Gelder an die Caisse de Con-

signation gezahlt.

Hinweis zur Bekanntmachung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, im Oktober 2014

Structured Invest S.A.
Silvia Mayers / Christoph Längsfeld

Référence de publication: 2014157006/9486/13.

Presence Communication, Société Anonyme.

Siège social: L-9647 Doncols, 36, Bohey.

R.C.S. Luxembourg B 135.091.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Qui se tiendra au siège social, en date du <i>27 octobre 2014 à 18 heures, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Modification au sein du Conseil d'Administration
2. Divers

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014156919/13.

Galor Holding S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 28.343.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du <i>28 octobre 2014 à 11 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation et approbation du rapport du commissaire aux comptes,
2. Approbation des comptes annuels de l'exercice clôturant au 30 juin 2014 et affectation du résultat,
3. Décharge au conseil d'administration et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014156807/506/16.

135172

L

U X E M B O U R G

Twin Holding 1 S.à.r.l, Société à responsabilité limitée soparfi.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1-3, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 131.271.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014133419/9.
(140151336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2014.

Suisimmo, Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 72.162.

RECTIFICATIF

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

le 24 juin 2014 sous la référence L140103559.

Ce dépôt est à remplacer par le dépôt suivant:
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour SUISIMMO
Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2014132805/15.
(140150532) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2014.

Thunder Holding S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 51.162.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à une

NOUVELLE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le vendredi <i>17 octobre 2014 à 10.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du liquidateur
2. Nomination du commissaire à la liquidation
3. Fixation de la date et de l'ordre du jour de la prochaine assemblée
Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014149787/755/16.

VC Holding II S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 155.264.

Die Bilanz zum 31. Dezember 2013 und die Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember 2013 abgelaufene

Geschäftsjahr wurden beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Munsbach, den 12. August 2014.

<i>Für VC Holding II S.à r.l.
Ein Beauftragter

Référence de publication: 2014132177/14.
(140149739) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2014.

135173

L

U X E M B O U R G

Demessy Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 131.701.

Due to lack of quorum to act on the item of the agenda regarding article 100, the Annual General Meeting held

exceptionally on September 29th, 2014 could not validly act on said item. The Shareholders are hereby convened to
attend the

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

which will be held on <i>November 10th, 2014 at 12.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:

<i>Agenda:

Action on a motion relating to the possible winding-up of the company as provided by Article 100 of the modified
Luxembourg law on commercial companies of August 10, 1915.

The shareholders are advised that the resolutions on the above mentioned agenda will be validly passed by a 2/3

majority of the shares present or represented and voting at the Meeting.

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2014156780/795/17.

Alistair Investissement S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 31, rue Notre-Dame.

R.C.S. Luxembourg B 119.916.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>21 octobre 2014 à 11.30 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l'exercice se clôturant au 30 juin 2014;

2. approbation des comptes annuels au 30 juin 2014;
3. affectation des résultats au 30 juin 2014;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014143825/10/18.

Ganges Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.009,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 165.870.

<i>Extrait des résolutions du conseil de gérance

En date du 14 juillet 2014, le conseil de gérance a décidé de transférer le siège social de la Société du 13-15 Avenue

de la Liberté, L-1931 Luxembourg au 6 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, et ce avec effet immédiat.

Nous vous prions également de bien vouloir prendre note du changement d'adresse des Gérants de classe B suivants:
Intertrust Management (Luxembourg) S.à r.l., 6 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
Hille-Paul Schut, 6 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
Cristina Lara, 6 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 août 2014.

Sophie Zintzen
<i>Mandataire

Référence de publication: 2014127859/19.
(140144967) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2014.

135174

L

U X E M B O U R G

CCI Participations SA, Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 52.273.

Par  la  présente,  je  démissionne  avec  effet  immédiat  de  ma  fonction  d'Administrateur  et  de  Président  du  Conseil

d'Administration de votre société CCI PARTICIPATIONS S.A. inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 52.273.

Luxembourg, le 1 

er

 août 2014.

Max GALOWICH.

Référence de publication: 2014127753/10.
(140145226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2014.

Olin Fund, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 28-32, place de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 135.803.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders held on September 15 

th

 , 2014 at 2.00 p.m. (Luxembourg time)

has not been able to deliberate validly on the below agenda as the quorum required has not been obtained. Consequently,
the Board of Directors reconvenes the Shareholders to an

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of OLIN FUND (the "Company") to be held in Luxembourg, before a Luxembourg Notary, <i> October 24 

<i>th

<i> , 2014 

 at

11.00 a.m. (Luxembourg time), at the registered office of the Company, 28-32, Place de la Gare, L-1616 Luxembourg,
with the same following agenda (the "Meeting"):

<i>Agenda:

1. Approval of main amendments of the Articles of Incorporation as follows:

1) Amendment of Article 1 "Form and denomination" in order to inter alia refer to the law dated July 12, 2013 on
alternative investment fund managers;

2. Amendment of Article 14 "Net Asset Value" in order use the new terminology on "custodian";
3. Adjunction of Article 25 "Preferential treatment of the Shareholders";
4. General rewording of Article 35 (formerly Article 34) "Depositary Bank".
II. Approval of the general renumbering of the Articles of Incorporation following the adjunction of articles from and

to the Articles of Incorporation.

In order to be able to deliberate validly on the agenda, the reconvened extraordinary general meeting will require no

quorum and the resolutions will be adopted if approved by two thirds (2/3) of the votes validly cast at the extraordinary
general meeting. Votes cast will not include votes attached to shares in respect of which the shareholder has not taken
part in the vote or has abstained or has returned a blank or invalid vote.

TERMS AND CONDITIONS TO ATTEND THE MEETING

1. Attendance at the Meeting

The shareholders will be allowed to attend the meeting, by giving proof of their identity. They are requested to inform

the Company, at its registered office (28-32, Place de la Gare, L-1616 Luxembourg / Administration "OLIN FUND" -
SGBT/SGSS/SSO/CTS/ING), by October 20 

th

 , 2014 at the latest, of their intention to attend the meeting in person.

Persons attending the meeting, in quality of registered shareholder, will be requested to produce to the general meeting

of shareholders concerned a blocking certificate which will certify the number of shares that they own in the books of
European Fund Services S.A. (28-32, Place de la Gare, L-1616 Luxembourg), to certify of their voting right.

2. Proxy Forms

Shareholders who will not be able to attend the Meeting may complete the enclosed form of proxy (the "Form of

Proxy") and date, sign and return a copy by fax and the original by mail before 6.00 p.m. CET on October 20 

th

 , 2014

to the attention of Mr Philippe DOYE (phone: 00352/26 15 16 274) or Miss Selma BAHTIC (phone: 00352/26 15 16 246)
or Mr Boris PAPEN (phone: 00352/26 15 16 334) at EUROPEAN FUND SERVICES S.A., 28-32, Place de la Gare, L-1616
Luxembourg (fax: 00352/475167).

Please note that any Forms of Proxy received after 6.00 p.m. CET on October 20 

th

 , 2014 or incomplete Forms of

Proxy will not be taken into account for the calculation of the quorum and the vote in respect of the Meeting of October
24 

th

 , 2014.

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2014145874/44.

135175

L

U X E M B O U R G

Titlis S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 32.613.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

qui aura lieu le <i>27 octobre 2014 à 16.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 30 juin 2013, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30

juin 2013.

4. Nominations statutaires.
5. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014157038/1023/17.

Chazur Property S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 174.008.

Par lettre recommandée adressée le 23 juillet 2014 à la société CHAZUR PROPERTY S.A. société anonyme avec siège

social à Luxembourg, 18, rue de l'Eau, la société FIDUCENTER S.A. a mis fin de plein droit au contrat de domiciliation
avec ladite société CHAZUR PROPERTY S.A avec effet immédiat. Le siège social est, partant, dénoncé.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCENTER S.A.
<i>Le domiciliataire

Référence de publication: 2014129267/12.
(140146293) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2014.

Altor CIB Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: SEK 3.438.072,00.

Siège social: L-1748 Findel, 7, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 145.367.

<i>Extrait des résolutions de l'actionnaire unique de la société Altor Cib Holding S.à r.l. (la «société») du 11 août 2014

1. Acceptation de la résignation de Edward Moore, né le 17 mai 1968 à Guildford, Royaume-Uni, résidant profession-

nellement au 11-15, Seaton Place, JE4 0QH, St Helier, Jersey, Channel Islands, en tant que gérant de catégorie A de la
Société avec effet le 6 août 2014.

2. Acceptation de la résignation de Alexander James Bermingham, né le 19 décembre 1972 à Sheffield, Royaume-Uni,

résidant professionnellement au 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, Grand-Duché de Luxembourg, en tant
que gérant de catégorie B de la Société avec effet le 6 août 2014.

3. Acceptation de la nomination de James Bermingham, né le 19 décembre 1972 à Sheffield, Royaume-Uni, résidant

professionnellement au 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Findel, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que gérant de catégorie
A de la Société avec effet le 7 août 2014.

4. Acceptation de la nomination de James Lees, né le 31 janvier 1978 à Belfast, Royaume-Uni, résidant professionnel-

lement au 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Findel, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que gérant de catégorie B de la
Société avec effet le 7 août 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 août 2014.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014129111/25.
(140146770) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2014.

135176

L

U X E M B O U R G

Aerlux, Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 67.091.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, le vendredi <i>17 octobre 2014 à 11.30

heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'administration et du Commissaire aux comptes sur les exercices clôturés au 31 décembre

2013;

2. Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2013;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. Affectation des résultats;
5. Décisions à prendre en application de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014149229/546/18.

President B, Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 112.835.

En date du 25 juillet 2014, l'associé unique a pris la décision suivante:
- Réélection du Commissaire aux comptes, Deloitte Audit, pour une période se terminant à l'assemblée générale

annuelle que se tiendra durant l'année 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

President B S.A.
TMF Luxembourg S.A.
Signatures
<i>Agent domiciliataire

Référence de publication: 2014127372/15.
(140144213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2014.

Essonne S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2628 Luxembourg, 3, rue des Trevires.

R.C.S. Luxembourg B 49.104.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de l'associé unique tenue extraordinairement le 4 juillet 2014

Les mandats de l'administrateur unique respectivement du commissaire aux comptes venant à échéance, l'Assemblée

décide de les renouveler pour une période expirant à la date de l'assemblée générale annuelle approuvant les comptes
annuels au 31 décembre 2014, comme suit:

<i>Conseil d'Administration:

DIMEST S.A., ayant son siège social au 3, rue des Bains, L-1212 Luxembourg, RCS Luxembourg B 176670, adminis-

trateur  unique,  dûment  représentée  par  son  administrateur  unique  Monsieur  Christophe  LAGUERRE,  demeurant
professionnellement au 3, rue des Bains L-1212 Luxembourg.

<i>Personne chargée du contrôle des comptes:

AUDIEX S.A., ayant son siège social au 9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg, RCS Luxembourg B 65469, com-

missaire aux comptes.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 août 2014.

<i>Pour la Société

Référence de publication: 2014127826/21.
(140144472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2014.

135177

L

U X E M B O U R G

Filmod International S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 63.875.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à une

ASSEMBLEE GENERALE

qui aura lieu le vendredi <i>17 octobre 2014 à 16.30 heures à Luxembourg, 16, Allée Marconi, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire.
2. Approbation des Comptes Annuels au 30.06.2014 et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Délibérations conformément à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
5. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014150507/504/16.

Valauchan Sopaneer International S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 5, rue Alphonse Weicker.

R.C.S. Luxembourg B 52.454.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>27 octobre 2014 à 16.00 heures en l'étude de Me Hellinckx sise 101 rue Cents à Luxembourg, afin de

délibérer sur l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Réduction de capital d'un montant de Euro 14.274.453 (quatorze millions deux cent soixante-quatorze mille quatre

cent cinquante-trois) par annulation de 9.516.302 (neuf millions cinq cent seize mille trois cent deux) actions propres
d'une valeur nominale de Euro 1,50 chacune. Le capital social est donc réduit de son montant de Euro 53.739.265,50
(cinquante-trois  millions  sept  cent  trente-neuf  mille  deux  cent  soixante-cinq  euros  et  cinquante  cents)  à  Euro
39.464.812,50 (trente-neuf millions quatre cent soixante-quatre mille huit cent douze euros et cinquante cents)
représenté par 26.309.875 (vingt-six millions trois cent neuf mille huit cent soixante-quinze) actions. Quinze actions
sont attribués aux actionnaires commandités, à raison de cinq actions par commandité, et sont non rachetables et
26.309.860 actions sont attribuées aux commanditaires.

2. Modification de l'alinéa 2 de l'article 13 qui aura désormais la teneur suivante : "Le Conseil de surveillance sera élu

par l'assemblée générale annuelle des actionnaires."

3. Modification subséquente des statuts ;
Les actionnaires sont avisés qu'un quorum de 50% des actions émises est requis pour délibérer sur les points de l'ordre

du jour. Si le quorum n'était pas atteint, une 2e Assemblée portant sur ces points devra être convoquée. Les résolutions
pour être valables devront réunir les 2 tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.

<i>Les Gérants-Commandités

Référence de publication: 2014157064/795/26.

Promox S.A. - SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 173.821.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

PROMOX S.A. - SPF
Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial
Signatures

Référence de publication: 2014127379/12.
(140143774) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2014.

135178

L

U X E M B O U R G

Valauchanrus Sopaneer S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 5, rue Alphonse Weicker.

R.C.S. Luxembourg B 140.847.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>27 octobre 2014 à 16.15 heures en l'étude de Me Hellinckx sise 101 rue Cents à Luxembourg, afin de

délibérer sur l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Réduction de capital d'un montant de Euro 4.313.725 (quatre millions trois cent treize mille sept cent vingt-cinq

euros) par annulation de 4.313.725 (quatre millions trois cent treize mille sept cent vingt-cinq) actions propres
d'une valeur nominale de Euro 1 chacune. Le capital social est donc réduit de son montant de Euro 25.833.000
(vingt-cinq millions huit cent trente-trois mille) à Euro 21.519.275 (vingt et un millions cinq cent dix-neuf mille deux
cent soixante-quinze) représenté par 21.519.275 (vingt et un millions cinq cent dix-neuf mille deux cent soixante-
quinze) actions. Deux actions sont attribués aux actionnaires commandités, à raison d'une action par commandité,
et sont non rachetables et 21.519.273 actions sont attribuées aux commanditaires.

2. Modification de l'alinéa 2 de l'article 13 qui aura désormais la teneur suivante : "Le Conseil de surveillance sera élu

par l'assemblée générale annuelle des actionnaires."

3. Modification du premier alinéa de l'article 8 qui aura désormais la teneur suivante : "Période d'acquisition d'Actions

Ordinaires:
Une fois par an, la Gérance aura la possibilité, sans en avoir l'obligation, de fixer une période (ci-après la " Période
d'acquisition d'Actions Ordinaires ") pendant laquelle les Commanditaires auront la possibilité d'acquérir des Ac-
tions Ordinaires de la Société. Si la Gérance décide de fixer une période de souscription, les Commanditaires
devront alors être informés par la Gérance de la date de commencement et de fin de la Période d'acquisition
d'Actions Ordinaires par décision publiée par voie d'affichage dans les locaux des sociétés du groupe Auchan ".

4. Modification subséquente des statuts;
Les actionnaires sont avisés qu'un quorum de 50% des actions émises est requis pour délibérer sur les points de l'ordre

du jour. Si le quorum n'était pas atteint, une 2e Assemblée portant sur ces points devra être convoquée. Les résolutions
pour être valables devront réunir les 2 tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.

<i>Les Gérants-Commandités

Référence de publication: 2014157065/795/32.

ContourGlobal Africa Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 156.688.

Par une convention de transfert de parts du 29 avril 2014, l'ensemble des cent (100) parts sociales de la Société

détenues jusqu'à lors par ContourGlobal Power Holdings S.A., ont été transférées comme suit et ceci avec effet au 29
avril 2014:

ContourGlobal Power Holdings S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à l'Atrium

Business Park, 33 rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 164.238, a transféré les cent (100) parts sociales de la
Société à KivuWatt Holdings Limited, une société régie par les lois de Gibraltar, ayant son siège social à 57/63 Line Wall
Road, Gibraltar, inscrite au Registre des Sociétés de Gibraltar sous le numéro 11427.

Dès lors, depuis le 29 avril 2014, les parts sociales de la Société sont distribuées comme suit:
KivuWatt Holdings Limited détient l'ensemble des cent (100) parts sociales de la Société d'une valeur nominale de

cent vingt-cinq euros (125 EUR) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Bertrange, le 11 août 2014.

<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014127724/22.
(140145076) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2014.

135179

L

U X E M B O U R G

ALG Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1748 Luxembourg-Findel, 4, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 174.398.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 Août 2014.

Référence de publication: 2014127652/10.
(140144506) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2014.

Heitman UCITS, Société d'Epargne-Pension à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 190.554.

STATUTES

In the year two thousand and fourteen, on the ninth day of September.
Before us, Maitre Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Heitman LLC, a Delaware limited liability company, having its principal place of business at 191 North Wacker Drive,

Suite 2500, Chicago, IL U.S.A. 60606 (the “Appearing Party”)

duly represented by Claude Niedner, lawyer, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Chicago, IL U.S.A. on the 8 

th

 day of September 2014.

The proxy given above is signed ne varietur by the Appearing Party and the undersigned notary and shall remain

annexed to this document to be filed with the registration authorities.

The Appearing Party, in the capacity in which it acts, has requested the notary to enact the deed of incorporation of

a public limited company (société anonyme) which the Appearing Party wishes to incorporate with the following articles
of incorporation (the "Articles"):

Chapter 1. Name, Duration, Purpose, Registered Office, Definitions

Art. 1. Name. Among the subscribers and all those who shall become Shareholders (as hereinafter defined) there exists

a company in the form of a public limited liability company (société anonyme) qualifying as an investment company with
variable share capital (société d'investissement à capital variable) under the name “Heitman UCITS” (hereinafter the
“Fund”).

Art. 2. Duration. The Fund has been set up for an undetermined period.

Art. 3. Purpose. The sole purpose of the Fund is to invest the funds available to it in various transferable securities or

other financial assets with the purpose of spreading investment risks and affording its Shareholders the results of the
management of its assets.

The Fund may take any steps and carry out any transactions that it deems useful for the achievement and development

of its purpose to the full extent allowed by part I of the law dated 17 December, 2010 relating to undertakings for collective
investment as may be amended from time to time (the “2010 Law”).

Art. 4. Registered Office. The registered office of the Fund (the “Registered Office”) is established in the city of

Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. Branches or other offices may be created by resolution of the board of
directors of the Fund (the “Board of Directors”) either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.

The Board of Directors may decide to transfer the Registered Office within the same municipality, or from a munici-

pality to another municipality within the Grand Duchy of Luxembourg, if and to the extent permitted by Luxembourg
law and practice relating to commercial companies.

If the Board of Directors deems that extraordinary events of a political or military nature, likely to jeopardize normal

activities at the Registered Office or smooth communication with this Registered Office or from this Registered Office
with other countries have occurred or are imminent, it may temporarily transfer this Registered Office abroad until such
time as these abnormal circumstances have fully ceased. However, this temporary measure shall not affect the Fund's
nationality, which notwithstanding this temporary transfer of the Registered Office, shall remain a Luxembourg company.

Art. 5. Definitions. 2010 Law means the law dated 17 December 2010 relating to undertakings for collective investment

as may be amended from time to time.

Board of Directors means the board of directors of the Fund, as may be appointed from time to time.

135180

L

U X E M B O U R G

Class or Classes means separate classes of Shares (as hereinafter defined) within each Sub-Fund.
Director means each director of the Fund.
Depositary means the banking or credit institution with which the Fund entered into a custody agreement as stated

in Article 28.

ESMA means the European Securities and Markets Authority.
EU means the European Union.
Investment Manager means the investment manager engaged to manage the portfolio of investments in any Sub-Fund.
KIID means the Key Investor Information Document(s) of each Class or each Sub-Fund.
Losses means all actions, proceedings, costs, charges, expenses, losses, damages or liabilities incurred or sustained by

a director of the Fund, as stated in Article 24.

Member State means a member state of the EU.
Money Market Instruments means financial instruments normally dealt on the money market and which are liquid and

have a value which can be accurately determined at any time.

NAV means the net asset value.
Other Regulated Market means a market which is not a Regulated Market and which is regulated, operates regularly

and is recognized and open to the public, namely a market (i) that meets the following cumulative criteria: liquidity;
multilateral order matching (general matching of bid and ask prices in order to establish a single price); transparency (the
circulation of complete information in order to give clients the possibility of tracking trades, thereby ensuring that their
orders are executed on current conditions); (ii) on which the securities are dealt in at a certain fixed frequency; (iii) which
is recognized by a State or by a public authority which has been delegated by that State or by another entity which is
recognized by that State or by that public authority, such as a professional association; and (iv) on which the securities
dealt are accessible to the public.

Other State means any sovereign state in America, Africa, Asia, Australia, Europe or Oceania which is not a Member

State.

Person means any individual, corporation, trust, partnership, association or any other entity with legal status.
Prospectus means the prospectus of the Fund, as the same may be amended from time to time.
Register of Shareholders means the register of Shareholders as stated in Article 7.
Registered Office means the registered office of the Fund as stated in Article 4.
Regulated Market means a market defined in the directive 2004/39/EC of the European Parliament and the European

Council of 21 April 2004 on markets in financial instruments.

Regulatory Authority means the Commission de Surveillance du Secteur Financier, the Luxembourg regulatory au-

thority in charge of the supervision of undertakings for collective investment in the Grand Duchy of Luxembourg.

Share means any share of any Class in any Sub-Fund.
Shareholder means the holder of any Share.
Sub-Fund means a specific portfolio of assets and liabilities held within the Fund as further described in Article 6, which

is invested in accordance with a particular investment objective and strategy.

Transferable Securities means one of the following:
- shares and other securities equivalent to shares;
- bonds and other debt instruments; or
- any other negotiable securities which carry the right to acquire any such transferable securities by subscription or

exchanges, with the exclusion of techniques and instruments.

UCI(s) means undertaking(s) for collective investment.
UCITS means undertaking(s) for collective investment in transferable securities, pursuant to Article 1, paragraph 2,

points a) and b) of Directive 2009/65/EC.

Valuation Date means a day, being typically each Business Day, where the NAV per Share of each Sub-Fund is deter-

mined.

Chapter 2. Capital, Variations in Capital, Features of the Shares

Art. 6. Capital. The capital of the Fund shall be represented by fully paid up Shares of no par value and will, at any time,

be equal to the net assets of the Fund.

Such Shares may, as the Board of Directors shall determine, be of different Sub-Funds of the Fund, each constituting

a different portfolio of assets and the proceeds of the issue of Shares of each Sub-Fund shall be invested pursuant to
Article 23 hereof in transferable securities or other financial assets corresponding to such geographical areas, industrial
sectors or monetary zones, or to such specific types of equity or debt securities, as the Board of Directors shall from
time to time determine in respect of each Sub-Fund.

The Board of Directors reserves itself the right to create new Sub-Funds and to fix the investment policy of these

Sub-Funds. Each Sub-Fund corresponds to a distinct part of the assets and liabilities of the Fund. Each Sub-Fund shall be,

135181

L

U X E M B O U R G

as between Shareholders thereof, invested for the exclusive benefit of the relevant Sub-Fund. With regard to third parties,
in particular towards the Fund's creditors, the assets of a Sub-Fund are exclusively liable for such liabilities attributable
to the Sub-Fund in question.

The Board of Directors may further decide to create within each Sub-Fund one or more classes of Shares (the “Class

(es)”) whose assets will be commonly invested pursuant to the specific investment policy of the relevant Sub-Fund. A
specific  sales  and  redemption  charge  structure,  fee  structure,  minimum  subscription  amount,  reference  currency  or
dividend policy, or any other characteristic as may be determined by the Board of Directors from time to time may be
applied to each Class.

The Board of Directors may create each Sub-Fund or Class for an unlimited or limited period of time; in the latter

case, the Board of Directors may, at the expiry of the initial period of time, extend the duration of the relevant Sub-Fund
or Class once or several times. At the expiry of the duration of the Sub-Fund or Class, the Fund shall redeem all the
Shares in the relevant Class(es), in accordance with the provisions of Article 12 below. At each extension of the duration
of a Sub-Fund or Class, the Shareholders shall be duly notified.

The minimum capital of the Fund shall be, as provided by law, one million two hundred and fifty thousand euros (EUR

1,250,000.00) or the equivalent in any other currency. The initial capital is three hundred thousand euros (EUR 300,000)
divided into three thousand (3,000) Shares without par value. The minimum capital of the Fund must be achieved within
six months after the date on which the Fund has been authorised as a UCITS under Luxembourg law.

For the purpose of determining the capital of the Fund, the net assets attributable to each Sub-Fund shall, if not

expressed in euro, be converted into euro and the capital shall be the total of the net assets of all Sub-Funds.

Art. 7. Shares. Shares in the Fund are in the form of Shares in a Sub-Fund. Shares in each Sub-Fund will be issued in

registered form only and without certificates. Shares must be fully paid up and carry no preferential or pre-emptive rights.

A confirmation of registration in the Register of Shareholders will be sent to Shareholders. Fractions of Shares shall

be issued, up to three (3) decimal places.

The Register of Shareholders shall be kept in Luxembourg at the Registered Office or at such other location in Lu-

xembourg designated for such purpose by the Board of Directors. There is no restriction on the number of Shares which
may be issued. The rights attached to Shares are those provided for in the Luxembourg law of 10 August 1915 on
commercial companies, as amended to the extent that such law has not been superseded by the 2010 Law and/or these
Articles. All entire Shares, whatever their value, have an equal voting right. No Shares have a priority right to liquidation
proceeds and/or distribution proceeds.

If payment made by any subscriber results in the issue of a Share fraction, the person entitled to such fraction shall

not be entitled to vote in respect of such fraction, but shall, to the extent the Fund shall determine as to calculation of
fractions, be entitled to dividends or other distributions on a pro rata basis.

Shares may be transferred by remittance to the Fund of a written statement of transfer, dated and signed by the

transferor and transferee, or by their duly authorised proxies as the case may be, who shall evidence the required powers.
Upon receipt of these documents satisfactory to the Board of Directors, transfers will be recorded in the Register of
Shareholders.

All Shareholders shall provide the Fund with an address to which all notices and information from the Fund may be

sent. The address shall also be indicated in the Register of Shareholders.

If a Shareholder does not provide the Fund with an address, this may be indicated in the Register of Shareholders, and

the Shareholder's address shall be deemed to be at the Fund's Registered Office or at any other address as may be fixed
periodically by the Fund until such time another address shall be provided by the Shareholder. Shareholders may change
at any time the address indicated in the Register of Shareholders by sending a written statement to the Registered Office
of the Fund, or to any other address that may be set by the Fund.

Shares may be held jointly, however, the Fund shall only recognize one person as having the right to exercise rights

in relation to each Share. Unless the Board of Directors agrees otherwise, the person entitled to exercise such rights
will be the person whose name appears first in the subscription form.

Art. 8. Limits on ownership of Shares. The Fund may restrict or prevent the ownership of Shares by any person, firm

or corporate body or prohibit certain practices (as disclosed in the Prospectus), if in the opinion of the Fund (i) such
holding, or practices such as market timing and late trading, may be detrimental to the Fund, (ii) such holding, or practices
such as market timing and lated trading, may result in a breach of any law or regulation, whether Luxembourg or foreign,
or (iii) as a result of such holding, or practices such as market timing and late trading, the Fund may become exposed to
tax disadvantages or other financial disadvantages that would not have otherwise incurred (such persons, firms or cor-
porate bodies to be determined by the Board of Directors being herein referred to as”Prohibited Persons”).

For such purposes the Fund may:
A. decline to issue any Shares and decline to register any transfer of a Share, where it appears to it that such registry

or transfer would or might result in legal or beneficial ownership of such Shares by a Prohibited Person; and

B. at any time require any person whose name is entered in, or any person seeking to register the transfer of Shares

on the Register of Shareholders, to furnish it with any information, supported by affidavit, which it may consider necessary

135182

L

U X E M B O U R G

for the purpose of determining whether or not beneficial ownership of such Shareholder's Shares rests in a Prohibited
Person, or whether such registry will result in beneficial ownership of such Shares by a Prohibited Person; and

C. decline to accept the vote of any Prohibited Person at any general meeting of Shareholders of the Fund; and
D. where it appears to the Fund that any Prohibited Person either alone or in conjunction with any other person is a

beneficial owner of Shares, direct such Person to sell such Shares and to provide to the Fund evidence of the sale within
thirty (30) days of the notice. If such Person fails to comply with such direction, the Fund may compulsorily redeem or
cause to be redeemed all such Shares in the following manner:

1. The Fund shall serve a second notice (the “purchase notice”) upon the Person holding such Shares or appearing in

the Register of Shareholders as the owner of the Shares to be purchased, specifying the Shares to be purchased as
aforesaid, the manner in which the purchase price will be calculated and the name of the purchaser.

Any such notice may be served upon such Person by posting the same in a registered envelope addressed to such

Person at his/her last address known to or appearing in the books of the Fund.

Immediately after the close of business on the date specified in the purchase notice, such Person shall cease to be the

owner of the Shares specified in such notice and his/her name shall be removed from the Register of Shareholders.

2. The price at which each such share is to be purchased (the “purchase price”) shall be an amount based on the NAV

per share of the relevant Sub-Fund as at the Valuation Date specified by the Board of Directors for the redemption of
Shares in the Fund next preceding the date of the purchase notice as determined in accordance with Article 12 hereof,
less any service charge provided therein.

3. Payment of the purchase price will be made available to the former owner of such Shares normally in the currency

fixed by the Board of Directors for the payment of the redemption price of the Shares of the relevant Sub-Fund and will
be deposited for payment to such owner by the Fund with the Depositary or at the request of such former owner
elsewhere (as specified in the purchase notice) upon final determination of the purchase price. Upon service of the
purchase notice as aforesaid such former owner shall have no further interest in such Shares or any of them, nor any
claim against the Fund or its assets in respect thereof, except the right to receive the purchase price (without interest)
from such bank. Any redemption proceeds receivable by a Person under this paragraph, but not collected within a period
of five years from the date specified in the purchase notice, may not thereafter be claimed and shall revert to the relevant
Sub-Fund or Sub-Funds. The Board of Directors shall have power from time to time to take all steps necessary to perfect
such reversion and to authorise such action on behalf of the Fund.

4. The exercise by the Fund of the power conferred by this Article shall not be questioned or invalidated in any case,

on the ground that there was insufficient evidence of ownership of Shares by any person or that the true ownership of
any Shares was otherwise than appeared to the Fund at the date of any purchase notice, provided in such case the said
powers were exercised by the Fund in good faith.

“Prohibited Person” as used herein does neither include any subscriber to Shares of the Fund issued in connection

with the incorporation of the Fund while such subscriber holds such Shares nor any securities dealer who acquires Shares
with a view to their distribution in connection with an issue of Shares by the Fund.

United States Persons as defined in this Article may, at the discretion of the Fund, constitute a specific category of

Prohibited Persons.

Where it appears to the Fund that any Prohibited Person is a United States Person, who either alone or in conjunction

with any other person is a beneficial owner of Shares, the Fund may compulsorily redeem or cause to be redeemed any
such Shares without delay. In such event, Clause D (1) here above shall not apply.

Whenever used in these Articles, the term “United States Person” shall have the same meaning provided within the

Prospectus.

Chapter 3. NAV, Issues, Redemptions and conversion of Shares, Suspension of the Calculation of NAV,

Issuing, Redeeming and converting Shares

Art. 9. NAV. The NAV per share of each Class shall be determined from time to time, but in no instance less than

twice monthly, in Luxembourg, under the responsibility of the Board of Directors (the date of determination of the NAV
is referred to in these Articles as the “Valuation Date”).

The NAV per share of each Class shall be expressed in the reference currency of the relevant Class.
The NAV per share of a Class is determined by dividing the net assets of the Fund corresponding to the Class, being

the value of the assets of the Fund corresponding to the Class less the liabilities attributable to the Class, by the number
of Shares of the relevant Class outstanding and shall be rounded up to three decimal places. Fractions of Shares will be
calculated by rounding down to three decimal places, and may be allocated as required.

If, since the last Valuation Date, there has been a material change in the quotations on the stock exchanges or markets

on which a substantial portion of the investments of the Fund attributable to a particular Class are quoted or dealt in,
the Fund may, in order to safeguard the interests of the Shareholders and the Fund, cancel the first valuation and carry
out a second valuation.

I. The value of the assets of the Fund shall be determined as follows:

135183

L

U X E M B O U R G

a. the value of any cash on hand or on deposit, bills and demand notes and accounts receivable, prepaid expenses, cash

dividends and interest declared or accrued as aforesaid and not yet received shall be deemed to be the full amount thereof,
unless, however, the same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof shall be determined
after making such discount as Board of Directors or any other persons appointed in accordance with Article 27 may
deem appropriate in such case to reflect the true value thereof;

b. the value of Transferable Securities, Money Market Instruments and any other assets which are quoted or dealt in

on any stock exchange shall be based on the latest available closing prices, it being understood that the Board of Directors
may in its discretion change this to the closing mid-market valuations or the valuation on a specific valuation point/time,
and Transferable Securities, Money Market Instruments and any other assets traded on any other Regulated Market shall
be valued in a manner as similar as possible to that provided for quoted securities;

c. The value of money market instruments not listed or dealt on any regulated market, stock exchange, or any other

regulated market and with remaining maturity of less than 12 months shall be valued by the amortised cost method, which
approximates market value.

d. for non-quoted assets or assets not traded or dealt in on any stock exchange or other Regulated Market, as well

as quoted or non-quoted assets on such other market for which no valuation price is available or assets for which the
listed prices are not representative of the fair market value, the value thereof shall be determined prudently and in good
faith by the Board of Directors or any other persons appointed in accordance with Article 27 on the basis of foreseeable
purchase and sale prices; after first seeking input from the Investment Manager and if still uncertain then escalating it to
the Board of Directors.

e. the administrative agent shall use the amortised cost method of valuation for short-term transferable debt securities

in any Sub-Funds. This method involves valuing a security at its cost and thereafter assuming a constant amortisation to
maturity of any discount or premium regardless of the impact of fluctuating interest rates on the market value of the
security or other instrument. While this method provides certainty in valuation, it may result in periods during which
value as determined by amortised cost, is higher or lower than the price the Sub-Fund would receive if it sold the securities.
This method of valuation will only be used in accordance with Committee of European Securities Regulators (CESR) (now
ESMA) guidelines concerning eligible assets for investments by UCITS and only with respect to securities with a maturity
at issuance or residual term to maturity of 397 days or less or securities that undergo regular yield adjustments at least
every 397 days.

f. shares or units in underlying open-ended UCIs shall be valued at their last determined and available net asset value

or, if such price is not representative of the fair market value of such assets, then the price shall be determined by the
Board of Directors or any other persons appointed in accordance with Article 27 on a fair and equitable basis. Units or
shares of a closed-ended UCI will be valued at their last available stock market value;

g. any money market instrument with a remaining maturity of less than ninety days at the time of purchase or securities

whose applicable interest rate or reference interest rate is adjusted at least any ninety days on the basis of market
conditions shall be valued at cost plus accrued interest from its date of acquisition, adjusted by an amount equal to the
sum of (i) any accrued interest paid on its acquisition and (ii) any premium or discount from its face amount paid or
credited at the time of its acquisition, multiplied by a fraction the numerator of which is the number of days elapsed from
its date of acquisition to the relevant Valuation Day and the denominator of which is the number of days between such
acquisition date and the maturity date of such instruments;

h. money market instruments with a remaining maturity of more than ninety days at the time of purchase shall be

valued at their market price. When their remaining maturity falls under ninety days, they shall be valued in accordance
with subsection (f).

i. liquid assets shall be valued at nominal value plus any accrued interest or on an amortized cost basis. All other assets,

where practice allows, shall be valued in the same manner.

j. the liquidating value of futures, forward and options contracts not traded on exchanges or on other regulated markets

shall mean their net liquidating value determined, by the Board of Directors or any other persons appointed in accordance
with Article 27 on a basis consistently applied for each different variety of contracts. The liquidating value of futures,
forward and options contracts traded on exchanges or on other regulated markets shall be based upon the last available
settlement prices of these contracts on exchanges and regulated markets on which the particular futures, forward or
options contracts are traded by the Fund; provided that if a futures, forward or options contract could not be liquidated
on the day with respect to which net assets are being determined, the basis for determining the liquidating value of such
contract shall be such value as the Board of Directors or any other persons appointed in accordance with Article 27 may
deem fair and reasonable after seeking input from the Investment Manager and if still uncertain then escalating it to the
Board of Directors.

k. the value of a credit default swap shall be determined by comparing it to the prevailing par market swap. A par

market swap is one which can be initiated in the market today for no exchange of principal, and its deal spread is such
that it results in the swap's market value being equal to zero. The spread between the initial default swap and the par
market swap is then discounted as an annuity using relevant risk-adjusted discount rates. Par market swap rates will be
obtained from a crosssection of market counterparties. Any other swaps shall be valued at their market value.

135184

L

U X E M B O U R G

k. all other assets of any kind or nature will be valued at their net realisable value as determined in good faith by the

Board of Directors or any other persons appointed in accordance with Article 27 in accordance with generally accepted
valuation principles and procedures after seeking consultation from the Investment Manager if needed and if still uncertain,
escalating it to the Board of Directors.

The Administrative Agent may seek authorization from the Board of Directors to apply other appropriate valuation

principles for the assets of the Fund and/or the assets of a given Class whenever the aforesaid valuation methods appear
impossible or inappropriate due to extraordinary circumstances or events.

The value of assets denominated in a currency other than the reference currency of a Sub-Fund shall be determined

by taking into account the rate of exchange prevailing at the time of the determination of the NAV.

The value of the Fund's assets is determined on the basis of information received from various pricing sources as

pricing and valuations from the Board of Directors or any other persons appointed in accordance with Article 27, effected
prudently and in good faith.

The value of assets and liabilities of the Fund and any Sub-Funds is generally determined in accordance with Luxembourg

generally accepted accounting principles.

In circumstances where, for any reason, the value of any asset(s) of the Fund may not be determined as rapidly and

accurately as required, as well as in circumstances where one or more pricing sources fail to provide valuations to the
Fund, the Board of Directors is authorized not to proceed with the valuation of the assets of the Fund, rendering the
calculation of subscription and redemption prices impossible. The Board of Directors may then decide to suspend the
NAV calculation, in accordance with the procedures set out in the section entitled “Suspension of the calculation of NAV,
of the issuing, redeeming and converting of Shares”.

II. The liabilities of the Fund shall include:
1. all loans, due bills and other suppliers' debts;
2. all known obligations, due or not, including all contractual obligations falling due and incurring payment in cash or

in kind (including the amount of dividends declared by the Fund but not yet distributed);

3. all reserves authorised or approved by the Board of Directors, in particular those set up as a means of meeting any

potential loss on certain investments by the Fund; and

4. all other commitments undertaken by the Fund, with the exception of those represented by Shares in the Fund. In

valuing the amount of other commitments, all expenses incurred by the Fund will be taken into account and include:

(a) upfront costs (including the cost of drawing up and printing the Prospectus, the Key Investor Information Document

(the “KIID”), notarial fees, fees for registration with administrative and stock exchange authorities and any other costs
relating to the incorporation and launch of the Fund and to registration of the Fund in other countries), and expenses
related to subsequent amendments to the Articles;

(b) the fees, including performance fees, and/or expenses of the investment manager(s) and adviser(s), the Depositary,

including the correspondents (clearing or banking system of the Depositary to whom the safekeeping of the Fund's assets
have been entrusted), domiciliary agents and all other agents of the Fund as well as the sales agent(s) under the terms of
any agreements with the Fund;

(c) legal expenses and annual audit fees incurred by the Fund,
(d) advertising and distribution costs;
(e) printing costs, translation (if necessary), publication and distribution of the half-yearly report and accounts, the

certified annual accounts and report and all expenses incurred in respect of the Prospectus, the KIID, publications in the
financial press and other documents made available to Shareholders;

(f) costs incurred by general meetings of Shareholders and meetings of the Board of Directors;
(g) remuneration (where applicable) for the Directors and reimbursement to the Directors of their reasonable tra-

velling or out-of-pocket expenses, hotel and other disbursements inherent in attending meetings of the Board of Directors
or administration committee meetings, or general meetings of Shareholders of the Fund;

(h) fees and expenses incurred in respect of registration (and maintenance of the registration) of the Fund (and/or

each Sub-Fund) with the public authorities or stock exchanges in order to license product selling or trading irrespective
of jurisdiction, including translation costs;

(i) office lease expenses;
(j) all taxes and duties levied by public authorities and stock exchanges;
(k) all other operating expenses, including licensing fees due for utilisation of stock indices and financing, banking and

brokerage fees incurred owing to the purchase or sale of assets or by any other means;

(l) all other administrative expenses.
In order to evaluate the extent of these liabilities, the Fund will keep account pro rata temporis of administrative or

other expenses which are of a regular or periodic nature.

III. There shall be established a pool of assets for each Sub-Fund in the following manner:

135185

L

U X E M B O U R G

(a) the proceeds from the issue of Shares of each Sub-Fund shall be applied in the books of the Fund to the pool of

assets established for that Sub-Fund, and the assets and liabilities and income and expenditure attributable thereto shall
be applied to such pool subject to the provisions of this Article;

(b) where any asset is derived from another asset, such derivative asset shall be applied in the books of the Fund to

the same pool as the asset from which it was derived and on each revaluation of an asset, the increase or decrease in
value shall be applied to the relevant pool;

(c) where the Fund incurs a liability which relates to any asset of a particular pool or to any action taken in connection

with an asset of a particular pool, such liability shall be allocated to the relevant pool provided that all liabilities, whatever
pool they are attributable to, shall unless otherwise agreed upon with the creditors, be binding upon the Fund as a whole,

(d) in the case where any asset or liability of the Fund cannot be considered as being attributable to a particular pool,

such asset or liability shall be equally divided between all the pools or, insofar as justified by the amounts, shall be allocated
to the pools pro rata to the NAVs of the relevant Sub-Funds;

(e) upon the payment of dividends to the Shareholders in any Sub-Fund, the NAV of such Sub-Fund shall be reduced

by the amount of such dividends.

As stated above, the Board of Directors may decide to create within each Sub-Fund one or more Classes whose assets

will be commonly invested pursuant to the specific investment policy of the Sub-Fund concerned but where a specific
sales or redemption charge structure, fee structure, minimum subscription amount, reference currency or dividend policy,
or any other specificity as may be determined by the Board of Directors from time to time and may be applied to each
Class. A separate NAV, which will differ as a consequence of these variable factors, will be calculated for each Class. If
one or more Classes have been created within the same Sub-Fund, the allocation rules set out above shall apply, as
appropriate, to such Classes.

Art. 10. Swing Pricing and Dilution Adjustments. As a result of certain duties, taxes, charges, interest costs, fees and

other costs, as well as spreads from buying and selling prices of the underlying investments of a Sub-Fund, all of which
have a dilutive effect on the value of such Sub-Fund, the actual cost of purchasing or selling a Sub-Fund's investments may
deviate from the valuation of such underlying investments in accordance with Article 9 of these Articles in the calculation
of the NAV per Share of such Sub-Fund or of a Class of such Sub-Fund. To mitigate the effects of any such dilution, the
Board of Directors or any other persons appointed in accordance with Article 27 may adjust the NAV per Share of such
Sub-Fund or Class of such Sub-Fund in the manner set out in the Prospectus (this is known as single swing pricing).

Art. 11. Pooling. The Board of Directors may decide to invest and manage all or any part of the pool of assets established

for two or more Sub-Funds (hereafter referred to as “Participating Funds”) on a pooled basis where it is appropriate with
regard to their respective investment sectors to do so. Any such asset pool (“Asset Pool”) shall first be formed by
transferring to it cash or other assets from each of the Participating Funds. Thereafter the Board of Directors may from
time to time make further transfers to the Asset Pool. They may also transfer assets from the Asset Pool to a Participating
Fund, up to the amount of the participation of the Participating Fund concerned. Assets other than cash may be contributed
to an Asset Pool concerned.

Art. 12. Issuing, redeeming and converting Shares. The Board of Directors is authorized to issue, at any time, additional

Shares that shall be fully paid up, at the price of the respective NAV per share of the Class, as determined in accordance
with Article 9 of the Articles, plus a possible subscription fee as may be determined in the Prospectus.

The price thus determined shall be payable in principle within three (3) Luxembourg bank business days after the date

as at which the applicable NAV is determined. The Board of Directors, at its sole discretion, reserves the right to cancel
any subscriptions in respect of which timely settlement is not made.

All new Shares issued are entitled to the same rights as the existing Shares of the same Class on the issue date.
The Fund may agree to issue Shares as consideration for a contribution in kind of securities, in compliance with the

conditions set forth by Luxembourg law, in particular the obligation, if applicable, to deliver a valuation report from the
authorised auditor of the Fund (réviseur d'entreprises agréé). The securities to be delivered by way of a contribution in
kind must correspond to the investment policy and restrictions of the Sub-Fund to which they are contributed. Any costs
incurred in connection with a contribution in kind of securities shall be borne by the relevant Shareholders.

The Board of Directors may, in its discretion, scale down or refuse to accept any application for Shares and may, from

time to time, determine minimum holdings or subscriptions of Shares of any Class of such number or value thereof as it
may think fit. When issuing new Shares, no preferential rights of subscription will be given to existing Shareholders.

Any Shareholder is entitled to apply to the Fund for the redemption of all or part of its Shares. The redemption price

shall normally be paid within three (3) Luxembourg bank business days after the date at which the NAV of the assets is
fixed and shall be equal to the NAV of the Shares as determined in accordance with the provisions of the above Article
9, less a possible redemption charge as fixed in the Fund's Prospectus, if any.

All redemption applications must be presented in writing by the Shareholder to the Registered Office or to another

company duly mandated by the Fund for the redemption of Shares.

If as a result of any request for redemption, the number or the aggregate NAV of the Shares held by any Shareholder

in any Class would fall below such number or such value as determined by the Board of Directors, then the Fund may

135186

L

U X E M B O U R G

decide that this request be treated as a request for redemption for the full balance of such Shareholder's holding of Shares
in such Class.

The Fund shall have the right, if the Board of Directors so determines, and with the express consent of the relevant

Shareholder, to satisfy payment of the redemption price to any Shareholder in specie by allocating to the Shareholder
investments from the portfolio of assets in such Class or Classes equal in value (as calculated in the manner described in
Article 9 hereof) as of the Valuation Date on which the redemption price is determined to the value of the Shares to be
redeemed. The nature and type of assets to be transferred in such case shall be determined on a fair and reasonable basis
and without prejudicing the interests of the other Shareholders of the Class or Classes and the valuation used shall be
confirmed, as applicable, by a special report of the authorised auditor of the Fund. The costs of any such transfers shall
be borne by the Shareholder.

Any Shareholder is entitled to apply the conversion of Shares of one Class held by him/her into Shares of another

Class. By applying the conversion method set out in the Prospectus, Shares of one Class shall be converted into Shares
of another Class on the basis of the respective NAVs per share of the different Sub-Funds/Classes, calculated in the
manner stipulated in Article 9 of these Articles.

The Board of Directors may set such restrictions it deems necessary as to the frequency of conversion. It may subject

conversion to the payment of reasonable costs which amount shall be determined by it.

Further, if on any given Valuation Date, redemption requests and conversion requests pursuant to this Article exceed

a certain level determined by the Board of Directors in relation to the number of Shares in issue in a specific Sub-Fund
being not less than 10% thereof, the Board of Directors may decide that part or all of such requests for redemption or
conversion will be deferred for a period and in a manner that the Board of Directors considers to be in the best interest
of the Fund. On the next Valuation Date following that period, these redemption and conversion requests will be given
priority settlement of later requests. Applications for Shares and requests for redemption or conversion must be received
at the Registered Office or at the offices of the establishments appointed for this purpose by the Board of Directors. The
Board of Directors may delegate the task of accepting applications for Shares and requests for redemption or conversion,
and delivering and receiving payment in respect of such transactions, to any duly authorised person.

Shares redeemed by the Fund may be cancelled.

Art. 13. Suspension of the calculation of NAV, of the issuing, redeeming and converting of Shares. The Board of

Directors is authorized to temporarily suspend the calculation of the NAV of one or more Classes of the Fund as well
as the issue, redemption and conversion of Shares under the following circumstances:

a. any period when any of the principal markets or stock exchange on which a substantial portion of the investments

of the Sub-Fund concerned is quoted or dealt in, is closed otherwise than for ordinary holidays, or during which dealings
therein are restricted or suspended; or

b. the existence of any state of affairs which constitutes an emergency as a result of which disposal or valuation of

assets of the Sub-Fund concerned would be impracticable; or

c. any breakdown in the means of communication or computation normally employed in determining the price or value

of the assets of the Sub-Fund concerned or the current prices or values on any market or stock exchange; or

d. any period when the Fund is unable to repatriate funds for the purpose of making payments on the redemption of

Shares or during which any transfer of funds involved in the realization or acquisition of investments or payments due on
redemption of Shares cannot in the opinion of the Board of Directors be effected at normal rates of exchange; or

e. any other circumstance or circumstances beyond the control and responsibility of the Board of Directors where a

failure to do so might result in the Fund or its Shareholders incurring any liability to taxation or suffering other pecuniary
disadvantages or other detriment which the Fund or its Shareholders might not otherwise have suffered; or

f. from the time of the publication or dispatch of a notice convening an extraordinary general meeting of Shareholders

to dissolve the Fund; or

g. following the suspension of the calculation of the NAV per share/unit at the level of a master fund in which the Sub-

Fund invests in its capacity as feeder fund of such master fund, to the extent applicable. The relevant Sub-Fund may suspend
the issue and redemption of its Shares from its Shareholders, as well as the conversion from and to Shares of each class,
following the suspension of the issue, redemption and/or conversion at the level of a master fund in which such Sub-Fund
invests in its capacity as a feeder fund of such master fund, to the extent applicable; or

h. where, in the unanimous opinion of the Board of Directors, any circumstances other than those described in any

of subclauses a. through g. above exist, as a result of which a failure to temporarily suspend the calculation of the NAV
of one or more Classes or Sub-Funds of the Fund or to temporarily suspend the issue, redemption and conversion of
Shares, whichever is applicable, could foreseeably have a material, adverse effect upon the Fund or its Shareholders which
the Fund or its Shareholders might not suffer if such temporary suspension were to occur.

Any such suspension shall be notified to the investors or Shareholders impacted, i.e. those who have made an appli-

cation for subscription, redemption or conversion of Shares for which the calculation of the NAV has been suspended.
Suspended subscription, redemption and conversion applications shall be processed on the first Valuation Date after the
suspension ends.

135187

L

U X E M B O U R G

Suspended redemption and conversion applications may be withdrawn by means of a written notice, provided the

Fund receives such notice before the suspension ends.

In the case where the suspension of the NAV exceeds a certain period determined by the Board of Directors, all

Shareholders of the relevant Sub-Fund will be personally notified.

Chapter 4. General meetings

Art. 14. Generalities. Any regularly constituted general meeting of Shareholders of the Fund shall represent all the

Fund's Shareholders. Its resolutions shall be binding upon all Shareholders of the Fund regardless of the Class held by
them. It has the broadest powers to organize, carry out or ratify all actions relating to the Fund's transactions.

Art. 15. Dates of general meetings of Shareholders. At least once per year, a general meeting of Shareholders shall be

held in accordance with Luxembourg law in Luxembourg, at the Registered Office or an adequate alternative location
that shall be indicated in the convening notice, on the third Thursday of the month of April at 3.00 pm CET (the “AGM”).
If this date is not a Luxembourg bank business day, the annual general meeting shall be held on the next Luxembourg
bank business day. The annual general meeting may be held abroad if the Board of Directors states at its discretion that
this is required by exceptional circumstances.

Other general meetings of Shareholders shall be held at the time and location specified in the notices of the meeting.

Art. 16. Organisation of meetings. The business transacted at any general meeting of Shareholders shall be limited to

the matters contained in the agenda (which shall include all matters required by law) and business incidental to such
matters.

The quorums and delays required by Luxembourg law shall govern the notice and the conduct of the general meetings

of Shareholders unless otherwise provided by these Articles.

Each entire share is entitled to one vote, whatever the Sub-Fund to which it belongs and whatever its NAV, in com-

pliance with Luxembourg law and these Articles. Each Shareholder may participate in the general meetings of Shareholders
by appointing in writing, by post, via electronic e-mail, facsimile, or any other similar means of communication another
person as proxy, who need not be a Shareholder and who may be a Director.

Insofar as the law or these Articles do not stipulate otherwise, the decisions of duly convened general meetings of

Shareholders shall be taken by the simply majority of the votes validly cast of Shareholders present or represented,
regardless of the portion of share capital represented. Abstention and nihil vote shall not be taken into account.

Each Shareholder may vote at a general meeting of Shareholders through a signed voting form sent by post, electronic

mail, facsimile or any other means of communication to the Registered Office or to the address specified in the convening
notice. The Shareholders may only use voting forms provided by the Fund which contain at least the place, date and time
of the general meeting, the agenda of the general meeting, the proposal submitted to the decision of the general meeting,
as well as for each proposal three boxes allowing the Shareholder to vote in favour of, against, or abstain from voting on
each proposed resolution by ticking the appropriate box.

Voting forms which, for a proposed resolution, do not show only (i) a vote in favour or (ii) a vote against the proposed

resolution or (iii) an abstention are void with respect to such resolution. The Fund shall only take into account voting
forms received prior to the general meeting which they relate to.

Art. 17. Convening general meetings of Shareholders. Shareholders shall meet upon call by the Board of Directors. A

general meeting of Shareholders must be called by the Board of Directors upon the request of Shareholders representing
at least one tenth of the share capital of the Fund. A notice setting forth the agenda shall be sent to all Shareholders by
mail, at least eight days before the general meeting, at the address indicated in the Register of Shareholders. No evidence
of the giving of such notice to Shareholders is required by the general meeting. The agenda shall be prepared by the Board
of Directors except in the instance where the general meeting is called on the written demand of the Shareholders in
which instance the Board of Directors may prepare a supplementary agenda.

Shareholders representing at least one tenth of the share capital may request the adjunction of one or several items

to the agenda of any general meeting of Shareholders. Such a request must be sent to the Registered Office by registered
mail at the latest five days before the relevant general meeting.

If all Shares are in registered form and if no publications are made, notices to Shareholders may be mailed by registered

mail only.

If all Shareholders are present or represented and consider themselves as being duly convened and informed of the

agenda, the general meeting of Shareholders may take place without prior notice of the relevant general meeting.

If a permanent chairperson of the Board of Directors is appointed, the permanent chairperson shall preside at all the

general meetings of Shareholders. If no permanent chairperson of the Board of Directors is appointed, the Directors
shall choose among themselves a chairperson or appoint any other person as chairperson to preside at any particular
general meeting of Shareholders or at all general meetings of Shareholders. Failing that, any general meeting of Share-
holders shall at the beginning of such general meeting of Shareholders appoint, with a majority vote, a person to serve
as chairperson of that general meeting of Shareholders.

135188

L

U X E M B O U R G

Chapter 5. Administration and management of the Fund

Art. 18. Administration. The Fund shall be administered by a Board of Directors composed of at least three members.

The members of the Board of Directors may, but are not required to be Shareholders of the Fund.

Art. 19. Duration of the function of Directors, renewal of the Board of Directors. The Directors shall be elected by

the annual general meeting of Shareholders for a maximum period of six years provided, however, that a Director may
be revoked at any time, with or without cause, and/or replaced upon a decision of the Shareholders, subject to the
approval of the Luxembourg supervisory authorities.

In the event an elected Director is a legal entity, a permanent individual representative thereof should be designated

as member of the Board of Directors. Such individual is submitted to the same obligations than the other Directors.

If the event of vacancy in the office of a Director because of death, resignation or otherwise, the remaining Directors

shall meet and elect, by majority vote, a Director to temporarily fulfil such vacancy until the next AGM. The Shareholders
shall take a final decision regarding such nomination at their next AGM.

Art. 20. Office of the Board of Directors. The Board of Directors may choose to appoint among its members a

permanent chairperson. If a permanent chairperson of the Board of Directors is appointed, the permanent chairperson
shall preside at all the meetings of the Board of Directors.

Should the Board of Directors choose not to appoint a permanent chairperson, it may establish a schedule pursuant

to which the chairperson position is filled on a rotating basis or it may appoint a temporary chairperson for and at the
beginning of each meeting of the Board of Directors.

The Board of Directors may elect, among its members, one or several vice-chairpersons. The Board of Directors may

also appoint a secretary who is not required to be a Director and who shall be responsible for keeping the minutes of
the meetings of the Board of Directors as well as of Shareholders.

Art. 21. Meetings and resolutions of the Board of Directors. Any one Director may at any time summon a meeting of

the Board of Directors by notice in writing to every other Director which notice shall set forth the general nature of the
business to be considered and the place at which the meeting is to be convened.

Written notice of any meeting of the Board of Directors shall be given to all Directors at least 72 hours before the

time provided for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and grounds of such emergency
shall be indicated in the notice of meeting. This notice of the meeting may be omitted subject to the consent of each
Director to be sent in writing, or by post, via electronic e-mail, facsimile or any other similar means of communication,
or when all Directors are present or represented at the meeting. A special notice of the meeting shall not be required
for a meeting of the Board of Directors to be held at a time and an address determined in a resolution previously adopted
by the Board of Directors.

Any Director may participate in any meeting of the Board of Directors by appointing in writing by post, via electronic

e-mail, facsimile or any other similar means of communication, another Director as proxy. One Director may act as proxy
holder for several other Directors.

The Directors may only act at duly convened meetings of the Board of Directors. The Directors may not bind the

Fund with his/her individual signatures, unless they are expressly authorized by a resolution of the Board of Directors.

The Board of Directors can deliberate or act validly only if at least the majority of the Board of Directors are present

or represented. Resolutions are taken by a majority vote of the Directors present or represented. In the event that at
any meeting the numbers of votes for or against a resolution are equal, the chairperson of the meeting shall have a casting
vote.

Any Director may participate in a meeting of the Board of Directors, or of any committee thereof, by conference call

or video conference or similar means of communications whereby all persons participating in the meeting can hear each
other, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting provided that no
Director physically present in the United Kingdom at the time of any such meeting may participate in a meeting by means
of conference call or video conference or similar means of communication.

Resolutions of the Board of Directors will be recorded in minutes signed by the chairperson of the meeting or by any

two Directors. Copies of extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or elsewhere will be validly
signed where they are signed by the chairperson of the meeting or any two Directors.

The Board of Directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by post, electronic e-mail, facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. Resolutions
in writing approved and signed by all Directors shall have the same effect as resolutions voted at the meetings of the
Board of Directors. The entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

Art. 22. Fund commitments towards third parties. The Fund shall be bound by the signatures of two Directors or by

that of a manager or any other person appointed in accordance with Article 27, who is duly appointed by the Board of
Directors for this purpose, or by the signature of any other person to whom the Board of Directors has specially delegated
powers. Subject to the consent of the general meeting of Shareholders, the Board of Directors may delegate the daily
management of the Fund's business to one or more of its members.

135189

L

U X E M B O U R G

Art. 23. Investment policy and investment restrictions.  The  Board  of  Directors,  based  upon  the  principle  of  risk

spreading, has the power to determine (i) the investment policies to be applied in respect of each Sub-Fund and (ii) the
course of conduct of the management and business affairs of the Fund, all within the restrictions as shall be set forth by
the Board of Directors in compliance with applicable laws and regulations, in particular, the provisions of part I of the
2010 Law.

In compliance with the requirements set forth by the 2010 Law and detailed in the Prospectus, in particular as to the

type of markets on which the assets may be purchased or the status of the issuer or of the counterparty, each Sub-Fund
may invest in:

1) Transferable Securities and Money Market Instruments listed or dealt in on a Regulated Market;
2) Transferable Securities and Money Market Instruments dealt in on an Other Regulated Market in a Member State;
3) Transferable Securities and Money Market Instruments admitted to official listing on a Regulated Market in an Other

State or dealt in on an Other Regulated Market in an Other State;

4) recently issued Transferable Securities and Money Market Instruments, provided that:
- the terms of issue include an undertaking that application will be made for admission to official listing on a Regulated

Market or on an Other Regulated Market as described under (1)- (3) above; and

- such admission is secured within one year of issue;
5) units of UCITS and/or other UCIs within the meaning of the first and second indent of Article 1 paragraph 2, points

a) and b) of Directive 2009/65/EC, whether situated in a Member State or in a State, provided that:

- such other UCIs are authorised under laws which provide that they are subject to supervision considered by the

Regulatory Authority to be equivalent to that laid down in Community law, and that cooperation between authorities is
sufficiently ensured;

- the level of protection for unitholders in such other UCIs is equivalent to that provided for unitholders in a UCITS,

and in particular that the rules on assets segregation, borrowing, lending, and uncovered sales of Transferable Securities
and Money Market Instruments are equivalent to the requirements of Directive 2009/65/EC;

- the business of the other UCIs is reported in half-yearly and annual reports to enable an assessment of the assets

and liabilities, income and operations over the reporting period;

- no more than 10 % of the assets of the UCITS or of the other UCIs, whose acquisition is contemplated, can, according

to their constitutional documents, in aggregate be invested in units of other UCITS or other UCIs;

6) deposits with credit institutions which are repayable on demand or have the right to be withdrawn, and maturing

in no more than 12 months, provided that the credit institution has its registered office in a Member State or, if the
registered office of the credit institution is situated in a State, provided that it is subject to prudential rules considered
by the Regulatory Authority as equivalent to those laid down in Community law;

7) financial derivative instruments, i.e. in particular credit default swaps, options, futures, including equivalent cash-

settled instruments, dealt in on a Regulated Market or on an Other Regulated Market referred to in (1), (2) and (3) above,
and/or financial derivative instruments dealt in OTC derivatives, provided that:

- the underlying consists of instruments covered by this Section A, financial indices, interest rates, foreign exchange

rates or currencies, in which a Sub-Fund may invest according to its investment objectives;

- the counterparties to OTC derivatives transactions are institutions subject to prudential supervision, and belonging

to the categories approved by the Regulatory Authority; and

- the OTC derivatives are subject to reliable and verifiable valuation and can be sold, liquidated or closed by an offsetting

transaction at their fair value at the Fund's initiative;

- under no circumstances shall these operations cause a Sub-Fund to diverge from its investment objectives.
8) Money Market Instruments other than those dealt in on a Regulated Market or on an Other Regulated Market, to

the extent that the issue or the issuer of such instruments is itself regulated for the purpose of protecting investors and
savings, and provided that such instruments are:

- issued or guaranteed by a central, regional or local authority or by a central bank of a Member State, the European

Central Bank, the EU or the European Investment Bank, a State or, in case of a federal state, by one of the members
making up the federation, or by a public international body to which one or more Member States belong; or

- issued by an undertaking any securities of which are dealt in on Regulated Markets or on Other Regulated Markets

referred to in (1), (2) or (3) above; or

- issued or guaranteed by an establishment subject to prudential supervision, in accordance with criteria defined by

European Community law, or by an establishment which is subject to and complies with prudential rules considered by
the Regulatory Authority to be at least as stringent as those laid down by European Community law; or

- issued by other bodies belonging to the categories approved by the Regulatory Authority provided that investments

in such instruments are subject to investor protection equivalent to that laid down in the first, the second or the third
indent listed above and provided that the issuer is a company whose capital and reserves amount to at least ten million
Euro (10,000,000 Euro) and which presents and publishes its annual accounts in accordance with directive 78/660/EEC
as amended, is an entity which, within a Group of Companies which includes one or several listed companies, is dedicated

135190

L

U X E M B O U R G

to the financing of the group or is an entity which is dedicated to the financing of securitisation vehicles which benefit
from a banking liquidity line.

9) Shares of another Sub-Fund (the “Target Sub-Fund”) provided that:
A. the Target Sub-Fund does not, in turn, invest in the Sub-Fund invested in this Target Sub-Fund; and
B. no more than 10% in aggregate of the assets of the Target Sub-Fund may be invested in units of other UCIs; and
C. voting rights attached to the relevant Shares of the Target Sub-Fund are suspended for as long as they are held by

such Sub-Fund, without prejudice to the appropriate processing in the accounts and the periodic reports; and

D. for as long as the relevant Shares of the Target Sub-Fund are held by another Sub-Fund, their value will not be taken

into consideration for the calculation of the net assets of the Fund for the purposes of verifying the minimum capital as
set out in Article 5; and

E. there is no duplication of management/subscription or redemption fees applied by the Target Sub-Fund and the

investing Sub-Fund.

10) No Sub-Fund will invest more than 10% in aggregate of its NAV in units/shares of other UCITS or other UCIs

unless otherwise explicitly stated in the Prospectus in respect of any specific Sub-Fund(s). In particular, the Prospectus
may allow the investment in units of a master fund qualifying as a UCITS provided that the relevant Sub-Fund invests at
least 85% of its NAV in units/shares of such master fund and that such master fund shall neither itself be a feeder fund
nor hold units/shares of a feeder fund:

11) The investment policy of a Sub-Fund may be the replication of the composition of an index of securities or debt

securities recognized by the Regulatory Authority.

12) In accordance with the principle of risk spreading, each Sub-Fund is authorised to invest up to 100% of its net

assets in Transferable Securities and Money Market Instruments issued or guaranteed by a Member State, by its local
authorities, by any Other State which is a member of the Organization for Economic Cooperation and Development
("OECD") or the Group of Twenty (G20) such as the U.S., by the Republic of Singapore or by a public international body
of which one or more Member State(s) are member(s), provided that (i) such securities are part of at least six different
issues and (ii) the securities from any such issue do not account for more than 30% of the net assets of such Sub-Fund.

13) Investments of any Sub-Fund may be made either directly or indirectly through wholly-owned subsidiaries, as the

Board of Directors may from time to time decide and as described in the Prospectus. Reference in these Articles to
“investments”  and  “financial  assets”  shall  mean,  as  appropriate,  either  investments  made  and  assets  beneficially  held
directly or investments made and assets beneficially held indirectly through the aforesaid subsidiary.

14) The Sub-Funds are authorized (i) to employ techniques and instruments relating to transferable securities and

money market instruments provided that such techniques and instruments are used for the purpose of efficient portfolio
management (ii) to employ techniques and instruments for hedging purposes in the context of the management of its
assets and liabilities and (iii) to employ techniques and instruments for investment purposes.

Art. 24. Conflict of Interest. No contract or transaction that the Fund may enter into with other companies or firms

may be affected or invalidated by the fact that one or several of the Directors or managers have an interest of whatever
nature in another company or firm, or by the fact that they may be directors, partners, managers or employees in another
company or firm. The director or manager or any other person appointed in accordance with Article 27 who is a director,
manager or employee in a company or firm with which the Fund enters into contracts, or with which it has other business
relations, shall not be deprived, on these grounds, of his/her right to deliberate, vote and act in matters relating to such
contract or business.

If a Director or manager or any other person appointed in accordance with Article 27 has a personal interest in any

of the Fund's business, such Director or manager of the Fund or any other person appointed in accordance with Article
27 shall inform the Board of Directors of this personal interest and he/she shall not deliberate or take part in the vote
on this matter. This matter and the personal interest of such Director or manager or any other person appointed in
accordance with Article 27 shall be reported at the next general meeting of Shareholders.

As it is used in the previous sentence, the term “personal interest” shall not apply to the relations or interests, positions

or transactions that may exist in whatever manner with companies or entities that the Board of Directors shall determine
at its discretion from time to time.

Art. 25. Compensation. Every Director, employee, manager or officer of the Fund or any other person appointed in

accordance with Article 27 and his/her personal representatives shall be indemnified and secured harmless out of the
assets and funds of the Fund against all actions, proceedings, costs, charges, expenses, losses, damages or liabilities (“Los-
ses”) incurred or sustained by him/her in or about the conduct of the Fund business or affairs or in the execution or
discharge of his/her duties, powers, authorities or discretions, including Losses incurred by him/her in defending (whether
successfully or otherwise) any civil proceedings concerning the Fund in any court whether in Luxembourg or elsewhere.
No such person shall be liable (i) for the acts, receipts, neglects, defaults or omissions of any other such person or (ii) by
reason of his/her having joined in any receipt for money not received by him/her personally or (iii) for any loss on account
of defect of title to any property of the Fund or (iv) on account of the insufficiency of any security in or upon which any
money of the Fund shall be invested or (v) for any loss incurred through any bank, broker or other agent or (vi) for any
loss, damage or misfortune whatsoever which may happen in or arise from the execution or discharge of the duties,

135191

L

U X E M B O U R G

powers, authorities, or discretions of his/her office or in relation thereto, unless the same shall happen through his/her
own gross negligence, fraud or wilful bad faith against the Fund.

Art. 26. The fees and expenses of the Board of Directors. Any general meeting of Shareholders may grant the Directors,

as remuneration for their activities, a fixed annual sum, in the form of Directors' fees, which shall be booked under the
Fund's overheads and distributed among the members of the Board of Directors, at its discretion.

In addition, the Directors may be reimbursed for expenses incurred by them in connection with their duties and

responsibilities as Directors of the Fund insofar as these are considered reasonable.

The fees of the chairperson or secretary of the Board of Directors, those of the managers shall be determined by the

Board of Directors.

Art. 27. Delegation of Board of Directors - Conducting Persons. The Board of Directors may delegate its powers to

conduct the day-to-day management and affairs of the Fund (including the right to act as authorised signatory for the
Fund) and its powers to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose to one or several physical
persons (the “Conducting Persons”) or corporate entities, who need not be members of the Board of Directors, who
shall have the powers determined by the Board of Directors and who may, if the Board of Directors so authorises, sub-
delegate their powers.

The Board of Director may also confer special powers of attorney by notarial or private proxy.

Art. 28. Depositary. To the extent required by law, the Fund shall enter into a custody agreement with a banking or

credit institution - a depositary (the “Depositary”) - as defined by the law of 5 April 1993 on the financial sector, as
amended. The Depositary shall fulfil the duties and responsibilities as provided for by the 2010 Law. If the Depositary
wishes to retire, the Board of Directors shall use its best endeavours to find a successor Depositary within two (2) months
of the effectiveness of such retirement. The Board of Directors may terminate the appointment of the Depositary but
shall not remove the Depositary unless and until a successor Depositary shall have been appointed to act in the place
thereof.

Chapter 6. Authorised Auditor

Art. 29. Authorised Auditor. The Fund's operations and its financial position, including in particular its bookkeeping,

shall be reviewed by one or several authorised auditors (réviseurs d'entreprises agréés) who shall satisfy the requirements
of the Luxembourg law relating to honourableness and professional experience, and who shall carry out the functions
prescribed by the 2010 Law.

The authorised auditors shall be elected by the AGM for a period ending at the date of the next AGM and until their

successors are elected. The authorised auditors in office may be replaced at any time by the Shareholders with or without
cause.

Chapter 7. Annual reports

Art. 30. Financial year. The financial year of the Fund will be the calendar year.

Art. 31. Allocation of results. Each year the AGM shall decide on the proposals made by the Board of Directors in

respect of distributions.

No distribution may be made if, as a result of the declaration of such distribution, the Fund's capital is less than the

minimum capital imposed by law.

Interim dividends may be paid out on the Shares of any Sub-Fund upon decision of the Board of Directors.
The dividends declared may, subject to such further conditions as set forth by the 2010 Law, be paid in euro or any

other currency selected by the Board of Directors and may be paid at such places and times as may be determined by
the Board of Directors. The Board of Directors may make a final determination of the rate of exchange applicable to
convert dividend funds into the currency of their payment. Dividends that have not been collected after five years following
their payment date shall lapse as far as the beneficiaries are concerned and shall revert to the Sub-Fund.

Chapter 8. Winding up, Liquidation

Art. 32. Liquidation of the Fund. The Fund is incorporated for an unlimited period and liquidation will normally be

decided by an extraordinary general meeting of Shareholders. This meeting will be convened in compliance with Luxem-
bourg law. For the avoidance of doubt, the quorum and majority requirements as for the procedure to amend the Articles
in accordance with Article 36 apply.

Special provisions apply in the following cases:
- If the net assets of the Fund fall below two thirds of the minimum capital as required by law (EUR 1,250,000.00), no

quorum is required and the decision will be taken by a simple majority of the Shares present or represented at the meeting
and validly voting; and

- If the net assets of the Fund fall below one quarter of the minimum capital as required by law, no quorum is required

and the decision will be taken by the Shareholders holding one quarter of the Shares present or represented at the
meeting;

135192

L

U X E M B O U R G

In the two cases mentioned above, the general meeting of Shareholders will be convened so that it is held within a

period of forty (40) days from the date on which it is ascertained that the net assets of the Fund has fallen below two-
thirds or one-fourth of the legal minimum, as applicable.

In the event that the Fund is dissolved, liquidation will proceed in accordance with the provisions of the Luxembourg

2010 Law which stipulate the measures to be taken to enable the Shareholders to participate in the distributions resulting
from liquidation and, in this context, it provides that all amounts which it has not been possible to distribute to the
Shareholders on completion of liquidation are to be deposited in trust with the Caisse de Consignation in Luxembourg.

Amounts not claimed within the prescribed period are liable to be forfeited in accordance with the provisions of

Luxembourg law. The net revenues resulting from the liquidation of each of the Sub-Funds will be distributed to the
Shareholders of the Sub-Fund in proportion to his/her/its respective shareholdings.

The decision of a court ordering the dissolution and liquidation of the Fund will be published in the Mémorial and in

two high-circulation newspapers, including at least one Luxembourg newspaper. These notices will be published at the
request of the liquidator.

Art. 33. Liquidation of Sub-Funds. The Board of Directors may decide to liquidate any Sub-Fund (i) if the net assets of

such Sub-Fund fall below a level considered by the Board of Directors to be too low for that Sub-Fund to continue to
be managed efficiently; (ii) if an unfavourable economic or political change would justify such liquidation as decided by the
Board of Directors; or (iii) in the event of a product rationalisation decided by the Board of Directors.

Shareholders will be notified by registered letter of the decision to liquidate prior to the effective date of the liquidation,

and the letter will indicate the reasons for, and the procedures of, the liquidation. Unless the Fund decides otherwise in
the interests of the Shareholders, or to keep equal treatment among the Shareholders, the Shareholders of the Sub-Fund
concerned may continue to request redemption or conversion of their Shares free of charge.

No later than nine months after a decision of the Board of Directors to terminate a Sub-Fund, (i) the liquidation of

the Sub-Fund will be closed and (ii) such proceeds of the liquidation which the Directors have been unable to distribute
to their beneficiaries shall be deposited with the Caisse de Consignation on behalf of the persons entitled thereto.

The liquidation of a Sub-Fund shall have no influence on any other Sub-Fund. The liquidation of the last remaining Sub-

Fund  will  result  in  the  liquidation  of  the  Fund  in  accordance  with  Article  32  above  and  will  require  the  vote  of  an
extraordinary general meeting of Shareholders.

Art. 34. Merger of the Fund. The Board of Directors may decide to proceed with a merger (within the meaning of the

2010 Law) of the Fund, either as receiving or absorbed UCITS, with:

- another existing or new Luxembourg or foreign UCITS or UCI (the “New Fund”); or
- a sub-fund thereof,
and, as appropriate, to redesignate the Shares of the Fund concerned as shares of this New Fund, or of the relevant

sub-fund thereof as applicable.

In case the Fund involved in a merger is the receiving UCITS (within the meaning of the 2010 Law), solely the Board

of Directors will decide on the merger and effective date thereof.

In the case the Fund involved in a merger is the absorbed UCITS (within the meaning of the 2010 Law), and hence

ceases to exist, the general meeting of Shareholders, rather than the Board of Directors, has to approve, and decide on
the effective date of, such merger by a resolution adopted with no quorum requirement and at a simple majority of the
votes cast at such meeting.

Such a merger shall be subject to the conditions and procedures imposed by the 2010 Law, in particular concerning

the merger project and the information to be provided to the Shareholders.

Shareholders will be entitled to request, without any charge other than those retained by the Fund or the Sub-Fund

to meet disinvestment costs, the redemption of their Shares in accordance with the provisions of the Law of 2010.

Art. 35. Merger of Sub-Funds. The Board of Directors may decide to proceed with a merger (within the meaning of

the Law of 2010) of any Sub-Fund, either as receiving or absorbed Sub-Fund, with:

- another existing or new Sub-Fund within the Fund or another sub-fund within a New Fund (the “New Sub-Fund”);

or

- a New Fund,
and, as appropriate, to redesignate the Shares of the Sub-Fund concerned as shares of the New Fund, or of the New

Sub-Fund as applicable.

Such a merger shall be subject to the conditions and procedures imposed by the Law of 2010, in particular concerning

the merger project and the information to be provided to the Shareholders.

Shareholders will be entitled to request, without any charge other than those retained by the Fund or the Sub-Fund

to meet disinvestment costs, the redemption of their Shares in accordance with the provisions of the Law of 2010.

Art. 36. Amendments to the Articles. These Articles may be amended as and when decided by a general meeting of

Shareholders in accordance with the voting and quorum conditions laid down by the Luxembourg law.

135193

L

U X E M B O U R G

Art. 37. Applicable Law. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the Law

dated 10 August 1915 on commercial companies and the 2010 Law, as such law have been or may be amended from time
to time.

<i>Transitory Dispositions

1) The first financial year will begin on the date of the incorporation of the Fund and end on 31 December 2015.
2) The first AGM will be held on 8 March 2016 at 3.00 pm CET.

<i>Subscription and Payment

The share capital of the Fund is subscribed as follows:
Heitman LLC, prequalified, subscribes for three thousand (3,000) shares of Class M of the Sub-Fund “Heitman European

Real Estate Opportunities”, for the price of EUR 300,000 (three hundred thousand euros).

The shares have been fully paid up by payment of the sum of EUR 300,000 (three hundred thousand euros) in cash,

evidence of which payment having been received so that the sum of EUR 300,000 (three hundred thousand) is at the
disposal of the Fund, all of which has been documented to the satisfaction of the undersigned notary.

<i>Expenses

The expenses which shall be borne by the Fund, as a result of its creation, are estimated at approximately EUR 3,000.-.

<i>Declaration

The undersigned notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Articles 26, 26-3 and

26-5 of the Law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, have been fulfilled and expressly bears witness
to their fulfilment.

<i>Resolutions of the sole shareholder

The Appearing Party, representing the entire subscribed capital and considering himself as fully convened, has passed

the following resolutions:

1) The number of Directors of the Fund is set out at three and the number of auditors at one.
2) The following are elected as Directors for a term to expire at the close of the AGM to be held in 2016 and until

their successors are elected and qualified:

- Mr. Taavi Davies, 5-11, avenue Gaston Diederich, L-1420 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, born on 25

May 1975 in Ukarumpa (Papua New Guinea);

- Mr. Serge Krancenblum, 412F route d'Esch, L-2086 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, born on 8 October

1961 in Metz (France); and

- Mr. Stuart C. Katz, 191 North Wacker Drive Suite 2500, Chicago, IL, U.S.A., born on 9 June 1937 in Chicago, Illinois

(U.S.A).

3) Ernst &amp; Young S.A. is appointed auditor (“réviseur d'entreprise agréé”) of the Fund for a period ending on the date

of the AGM to be held in 2016 and until its successor is elected and qualified.

4) The Registered Office is set at 26B, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
5) At the same time at which one or more additional shares of the Fund are issued resulting in a share capital of the

Fund of at least EUR 1,250,000, the 3,000 shares subscribed and held by Heitman LLC shall without further resolution
be automatically cancelled, provided that Heitman LLC still is the holder of such 3,000 shares at such time. As a conse-
quence of the cancellation, the initial subscription price of EUR 300,000 shall be repaid to Heitman LLC.

Whereof, this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date at the beginning of this deed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the Appearing Party,

this deed is worded in English.

This  deed  having  been  given  for  reading  to  the  proxyholder  of  the  Appearing  Party,  the  said  proxyholder  of  the

Appearing Party signed together with us, the notary, the present deed.

Signé: C. NIEDNER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 10 septembre 2014. Relation: LAC/2014/42117. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 30 septembre 2014.

Référence de publication: 2014151586/838.
(140173022) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2014.

135194

L

U X E M B O U R G

Manulife Global Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-8070 Bertrange, 31, Zone d'Activités Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 26.141.

We are pleased to invite you to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders of Manulife Global Fund to be held at the offices of the Company's Administrator, Citibank International

plc (Luxembourg Branch) 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg at 11.00 a.m. <i>on October
17, 2014, for the purpose of considering and voting upon the following agenda:

<i>Agenda:

1. Review of the report of the Board of Directors to the shareholders for the financial year ended June 30, 2014;
2. Review of the auditor's report for the financial year ended June 30, 2014;
3. Approval of the audited annual accounts of the Company for the financial year ended June 30, 2014;
4. Declaration of the Final Dividend;
5. Discharge of Mr. Robert Allen Cook, Dr. Yves Wagner, Mr. Christakis Partassides and Mrs. Donna Cotter as

Directors of the Company in respect of the carrying out of their duties for the financial year ended on June 30,
2014 as well to Mr. George T Yoxall for the period from July 1, 2013 until December 31, 2013 and Mr. Paul Smith
for the period from December 31, 2013 until June 30, 2014;

6. Re-election of Mr. Robert Allen Cook (residing in Hong Kong), Dr. Yves Wagner (residing in Luxembourg), Mrs.

Donna Cotter (residing in Hong Kong) and Mr. Christakis Partassides (residing in Cyprus), as Directors of the
Company until the next Annual General Meeting scheduled in 2015;

7. Election of Mr. Paul Smith (residing in Hong Kong) as Director of the Company until the next Annual General

Meeting scheduled in 2015;

8. Election of the Mr. Clive Anderson (residing in Hong Kong) as Director of the Company until the next Annual

General Meeting scheduled in 2015;

9. Re-election of the Auditors of the Company, PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, for the financial year

beginning on July 1, 2014 and until the next Annual General Meeting of Shareholders approving the accounts for
the financial year ending on June 30, 2015;

10. Ratification of the Directors' remuneration paid for the financial year ended June 30, 2014 and approval of the

Directors' remuneration to be paid for the financial year ending June 30, 2015;

11. Miscellaneous.

Resolutions on the agenda of the Annual General Meeting will require no quorum and will be taken at the majority of

the votes expressed by the shareholders present or represented at the meeting.

Shareholders who are unable to attend the Meeting in person are invited to send a duly completed and signed proxy

form to Ms Laurence Kreicher, Citibank International plc (Luxembourg Branch), by mail to 31, Z.A. Bourmicht, L-8070
Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, or by fax to +352 45 14 14 439 no later than October 15, 2014. Proxy forms
will be sent to registered shareholders with a copy of this notice and can also be obtained from the Company's Admin-
istrator at the above-mentioned address in Bertrange.

Copy of the Annual Report of the Company for the year ended on June 30, 2014 is available in electronic format at

www.manulifefunds.com.hk via the web-path "Forms &amp; Documents > Annual Reports > Download" and in printed format
for collection free of charge at the following locations, subject to inventory availability:

* 22/F, Tower A, Manulife Financial Centre, 223-231 Wai Yip Street, Kwun Tong, Hong Kong

* Avenida Praia Grande. No. 517, 8 andar, Edif. Commercial NamTung, Macau

* 9F, 89 SongRen Road, XinYi District, Taipei 11073, Taiwan

* 1 Kim Seng Promenade #11-07/08, Great World City West Tower, Singapore 237994

* 10 King William Street, London, EC4N 7TW

* 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg

Shareholders requiring further information may contact the Administrator of the Company, Citibank International plc

(Luxembourg Branch) on telephone number (352) 45 14 14 258, or fax number (352) 45 14 14 332, or the Hong Kong
Distributor, Manulife Asset Management (Hong Kong) Limited, on telephone number (852) 2108 1110, or fax number
(852) 2810 9510, at any time during normal local business hours.

Référence de publication: 2014149789/755/53.

135195

L

U X E M B O U R G

Société Générale Private Wealth Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 60.963.

L'an deux mille quatorze, le vingt-six septembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg),

A COMPARU

«Société Générale Bank &amp; Trust», une société anonyme, ayant son siège social au 11, avenue Emile Reuter, Luxem-

bourg,

ici représentée par Madame Marie Magonet, employée privée, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration

sous seing privé donnée à Luxembourg.

La procuration paraphée ne varietur par la mandataire de la comparante et par le notaire soussigné restera annexée

au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La comparante est l'associé unique de «Société Générale Private Wealth Management S.A.», établie et ayant son siège

social au 11, avenue Emile Reuter, Luxembourg, ci-après dénommée la «Société», inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 60963, constituée suivant acte notarié du 1 

er

 octobre 1997, publié

au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 197 du 31 mars 1998. Les statuts de la Société ont été
modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 12 septembre
2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2736 du 02 novembre 2013.

La comparante, représentant l'intégralité du capital social de la Société, a requis le notaire instrumentant d'acter la

résolution suivante:

<i>Résolution

L'actionnaire unique décide de modifier l'article 3 des statuts par la mise à jour des références aux loi et directive

conformément à la Loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et à son annexe
I telle que modifiée de temps à autre.

En conséquence, l'article 3 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

Art. 3. La Société a pour objet la gestion collective de portefeuille d'un ou plusieurs (i) organismes de placement

collectif en valeurs mobilières, autorisés conformément à la Directive 2009/65/CEE, telle que modifiée de temps à autre
(«OPCVM»), (ii) fonds d'investissement alternatifs au sens de la Directive 2011/61/UE, telle que modifiée de temps à
autre («FIA») (iii) autres organismes de placement collectif qui ne relèvent pas de ces Directives («autres OPC») et de
fonds interne collectifs d'assurance-vie pour le compte de leurs porteurs de parts ou de leurs actionnaires, conformément
aux dispositions du chapitre 15 de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 relative aux organismes de placement
collectif, telle que modifiée de temps à autre (la «Loi de 2010) et de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de
fonds d'investissement alternatifs, telle que modifiée de temps à autre (la «Loi de 2013»).

Cette activité de gestion inclut la gestion, l'administration et la commercialisation de ces organismes de placement

collectif au sens de l'annexe II de la Loi de 2010 et de l'annexe I de la Loi de 2013.

Par ailleurs la Société pourra exercer les fonctions suivantes:
- Le conseil en investissement.
- La gestion discrétionnaire.
- La réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers.
De  plus  la  Société  pourra  exercer  toutes  les  activités  estimées  utiles  à  l'accomplissement  de  son  objet  social  en

respectant toutefois les dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, du Chapitre 15 de
la Loi de 2010 et de la Loi de 2013.»

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
Après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, connue du notaire instrumentaire par

nom, prénom, état et demeure, la mandataire de la comparante a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M. MAGONET, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 01 octobre 2014. Relation: EAC/2014/13242. Reçu soixante-quinze Euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur ff. (signé): Monique HALSDORF.

Référence de publication: 2014153130/53.
(140174882) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2014.

135196

L

U X E M B O U R G

FINIMPEX S.A., société de gestion de patrimoine familial, Société Anonyme - Société de Gestion de

Patrimoine Familial.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 19.076.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue le 30 décembre 2013, que

la liquidation de la société décidée en date du 23 décembre 2013 a été clôturée; et que la société FINIMPEX S.A., société
de gestion de patrimoine familial, a définitivement cessé d'exister. Les livres et documents sociaux sont déposés et con-
servés pour une période de cinq ans au 42 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg.

Luxembourg, le 11 août 2014.

<i>Pour: FINIMPEX S.A. société de gestion de patrimoine familial
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme

Référence de publication: 2014127854/18.
(140145199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2014.

Renson &amp; Associates Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4960 Clemency, 2, rue de Bascharage.

R.C.S. Luxembourg B 159.941.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 11 août 2014.

Référence de publication: 2014128159/10.
(140145182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2014.

TRIWO Technopark Aachen Development S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6614 Wasserbillig, 43, rue du Bocksberg.

R.C.S. Luxembourg B 134.161.

Im Jahre zweitausendundvierzehn, am fünfundzwanzigsten Juli.
Vor Notar Jean SECKLER, mit Amtssitz in Junglinster, Grossherzogtum Luxemburg.

Sind erschienen:

1.- Triwo AG, eine nach deutschem Recht gegründete Aktiengesellschaft mit Sitz in Ostallee 3-5, 54290 Trier, Deuts-

chland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Wittlich unter HRB 2591, und

2.- IBG Immobilien Beteiligungsgesellschaft mbH, eine nach deutschem Recht gegründete Gesellschaft mit beschränkter

Haftung mit Sitz in Ostallee 3-5, 54290 Trier, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Wittlich
unter HRB 42177,

beide hier vertreten durch Frau Christina SCHMIT, Angestellte, beruflich ansässig in Junglinster, auf Grund zwei unter

Privatschrift erteilten Vollmachten.

Welche Vollmachten, von der Vollmachtnehmerin und dem instrumentierenden Notar „ne varietur“ unterschrieben,

bleiben gegenwärtiger Urkunde beigebogen um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

Die Komparentinen, vertreten wie eingangs erwähnt, handelnd in ihrer Eigenschaft als alleinige Gesellschafter welche

das gesamte Gesellschaftskapital der TRIWO Technopark Aachen Development S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter
Haftung (“société à responsabilité limitée”) unter luxemburgischem Recht, mit Sitz in L-6868 Wecker, Am Scheerleck,
eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg («Registre de Commerce et des Sociétés de Lu-
xembourg»), Sektion B, unter der Nummer 134.161 («die Gesellschaft»).

Die Gesellschaft wurde ursprünglinch unter dem Namen PATRON ALPINE II S.à r.l. gegründet gemäß Urkunde von

Notar Henri HELLINCKX, mit Amtssitz in Luxemburg vom 16. November 2007, veröffentlicht im Memorial C Recueil
des Sociétés et Associations, Nummer 109 vom 15. Januar 2008, wessen Statuten zum letzten mal abgeändert wurden
gemäß Urkunde von Notar Jean SECKLER, mit Amtssitz in Junglinster vom 20. Februar 2013, veröffentlicht im Memorial
C Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 999 vom 26 avril 2013.

Die Erschienenen, haben den amtierenden Notar beauftragt, folgende Beschluss, welche einstimmig in der gegenwär-

tigen AusserOrdentlichen Gesellschafterversammlung genommen wurden, zu berurkunden:

135197

L

U X E M B O U R G

<i>Einziger Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Sitz der Gesellschaft nach L-6614 Wasserbillig, 43, rue du Bocksberg zu

verlegen, und somit den 1. Satz von Artikel 5 der Satzung abzuändern wie folgt:

« Art. 5. (1. Satz). Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Mertert.»

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen, am Datum wie eingangs erwähnt in Junglinster.

<i>Kosten

Die  Kosten  und  Gebühren  dieser  Urkunde,  welche  auf  insgesamt  900  Euro  veranschlagt  sind,  sind  zu  Lasten  der

Gesellschaft.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen

Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, hat dieser mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Christina SCHMIT, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 29 juillet 2014. Relation GRE/2014/3004. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2014128287/44.
(140144642) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2014.

Thebes Capital Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 136.961.

Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014128280/9.
(140145056) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2014.

Helvetia Capital Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 67.716.

L’an deux-mille quatorze, le cinq août.
Par devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est réunie

l’assemblée générale extraordinaire (ci-après «l’Assemblée Générale») des actionnaires de la société Helvetia Capital

Holding S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 67.716, constituée suivant un acte reçu par Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage,
Grand-Duché de Luxembourg, en date du 21 décembre 1998, publié au Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 159, le 11 mars 1999 (ci-après la «Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par
un acte de Maître Paul Frieders, notaire alors de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 27
décembre 2006, publié au Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations, numéro 508, le 2 avril 2007.

L’Assemblée Générale est ouverte sous la présidence de Madame Peggy Simon, employée privée, demeurant profes-

sionnellement à Echternach, 9, Rabatt,

qui se nomme elle-même comme scrutateur et qui désigne comme secrétaire Madame Mariette Schou, employée

privée, demeurant professionnellement à Echternach, 9, Rabatt,

La président déclare et prie le notaire d’acter:
I. que la majorité des actionnaires est représentée et le nombre d’actions qu’ils détiennent est renseigné sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que
les procurations, resteront annexées au présent acte.

II. qu’il appert de cette liste de présence que sur les deux mille deux cents (2.200) actions représentant l’intégralité

du capital social de la Société actuellement fixé à deux cent vingt mille euros (220.000,- EUR), deux mille cent cinquante
(2.150) actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR), représentant plus de la moitié du capital social, sont
représentées à la présente Assemblée Générale, de sorte que l’Assemblée Générale peut décider valablement sur tous
les points portés à son ordre du jour.

III. que l’ordre du jour de l’Assemblée Générale est rédigé comme suit:

135198

L

U X E M B O U R G

1. prise de connaissance du rapport établi par Deloitte Audit S.à r.l., en qualité de réviseur d’entreprises agréé, con-

formément aux articles 266 paragraphe (3) et 26-1 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle
que modifiée (la «Loi»);

2. reconnaissance de ce que toutes les formalités requises par l’article 267 de la Loi ont été dûment remplies;
3. approbation (i) du projet de fusion publié au Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro

1675, le 30 juin 2014 (le «Projet de Fusion»), et (ii) de la fusion par absorption (la «Fusion») par Hottinger Financial S.A.,
une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 82.359,
en tant que société absorbante (la «Société Absorbante»), de la Société, en tant que société absorbée;

4. reconnaissance de l’accomplissement des conditions suspensives à la Fusion;
5. reconnaissance qu’aucune objection à la Fusion n’a été reçue entre la date de publication du Projet de Fusion au

Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations et la date de l’Assemblée Générale approuvant la Fusion;

6. reconnaissance qu’en accord avec le Projet de Fusion, la Fusion est effective pour des raisons comptables au 1 

er

janvier 2014;

7. décision qu’à la suite de la Fusion, le mandat des administrateurs de la Société prendra fin;
8. décision de donner quitus aux administrateurs de la Société pour l’exécution de leur mandat;
9. délégation de pouvoirs aux administrateurs de la Société Absorbante au vue d’accomplir et de signer tous les actes

nécessaires ou utiles à la mise en oeuvre des résolutions envisagées; et

10. divers.
VI. que l’Assemblée Générale a pris à la majorité les décisions suivantes:

<i>Première décision

L’Assemblée Générale reconnaît que les actionnaires de la Société ont renoncé lors d’une assemblée générale en date

du 20 juin 2014, à l’examen du Projet de Fusion par un réviseur d’entreprises agréé et à l’établissement d’un rapport d’un
expert sur la Fusion prévu par l’article 266 de la Loi, et d’un rapport écrit détaillé établi par le conseil d’administration
expliquant et justifiant la Fusion d’un point de vue juridique et économique, conformément aux articles 266 paragraphe
(5) et 265 paragraphe (3) de la Loi.

L’Assemblée Générale prend acte du rapport sur les apports autres qu’en numéraire qui a été établi conformément

aux articles 266 paragraphe (3) et 26-1 de la Loi, par Deloitte Audit S.à r.l., ayant son siège social au 560, rue de Neudorf,
L-2220 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en qualité de réviseur d’entreprises agréé.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale reconnaît, que toutes les formalités requises par l’article 267 de la Loi ont été remplies.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale approuve (i) le Projet de Fusion et (ii) la Fusion.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée Générale reconnaît que les conditions suspensives à la Fusion telles que mentionnées à l’article 10 du

Projet de Fusion ont été accomplies.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée Générale reconnaît qu’aucune objection à la Fusion n’a été reçue entre la date de publication du Projet

de Fusion au Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations et la date de la présente Assemblée Générale approuvant
la Fusion.

<i>Sixième résolution

L’Assemblée Générale reconnaît qu’en accord avec l’article 5 du Projet de Fusion, la Fusion est effective pour des

raisons comptables, au 1 

er

 janvier 2014.

<i>Septième résolution

L’Assemblée Générale décide qu’à la suite de la Fusion, le mandat des administrateurs de la Société prendra fin.

<i>Huitième résolution

L’Assemblée Générale décide de donner quitus aux administrateurs de la Société pour l’exécution de leurs mandats

jusqu’à la date d’effet de la Fusion.

<i>Neuvième résolution

L’Assemblée Générale prend acte qu’il a été confié tous pouvoirs aux administrateurs de la Société Absorbante en

vue d’accomplir et de signer tous les actes nécessaires ou utiles à la mise en oeuvre des résolutions ci-dessus.

135199

L

U X E M B O U R G

<i>Déclaration

Conformément à l’article 271 (2) de la Loi, le notaire instrumentant déclare qu’il a vérifié et confirme l’existence et la

validité des mesures et formalités exigées par la Loi par rapport à la Société et au Projet de Fusion.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société à raison des

présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille six cents Euros (EUR 1.600.-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont Procès-verbal, fait et passé à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des

présentes.

Lecture faite et interprétation donnée aux comparantes de tout ce qui précède, ces dernières, toutes connues du

notaire instrumentant par noms, prénoms, états et demeures, ont signé ensemble avec nous notaire, le présent acte.

Signé: P. SIMON, M. SCHOU, Henri BECK
Enregistré à Echternach, le 07 août 2014. Relation: ECH/2014/1481. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): J.-M. MINY.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 11 août 2014.

Référence de publication: 2014128669/99.
(140145342) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2014.

Pro-Vision BRD S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 128.480.

Le Bilan au 31 mars 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014127375/9.
(140144207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2014.

Pro-Vision S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 105.420.

Le comptes annuels au 31 mars 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014127377/9.
(140144208) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2014.

Rive Private Investment, Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 8, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 178.767.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 08/08/2014.

Référence de publication: 2014127395/10.
(140144141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2014.

Sustainable Assets No. 2, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 188.491.

Im Jahre zweitausendundvierzehn, am achtunzwanzigsten Juli.
Vor dem unterzeichneten Notar Martine SCHAEFFER, im Amtssitze in Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

135200

L

U X E M B O U R G

Aquila Capital Holding GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet und wirksam bestehend nach

deutschem Recht, mit Gesellschaftssitz in Valentinskamp 70, 20355 Hamburg, Deutschland und im Handelsregister des
Amtsgerichts Hamburg eingetragen unter der Nummer HRB 115145,

hier vertreten durch Andrea München, geb. am 23. August 1979, mit Geschäftsanschrift in Westhafenplatz 1, 60323

Frankfurt am Main, aufgrund einer privatschriftlichen, am 25. Juni 2014 erteilten Vollmacht, welche der ursprünglichen
Urkunde vom 27 Juni 2014, beigefügt bleibt und mit ihr einregistriert wurde.

Die Erschienene erklärt dass, laut Gründungsurkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 27. Juni

2014,  Nummer  1547/2014  Ihres  Répertoires,  einregistriert  in  Luxemburg  am  4.  Juli  2014  unter  Nummer  LAC/
2014/31304, eingetragen im Handelsregister in Luxemburg unter der Nummer L140119951, noch nicht veröffentlicht im
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, irrtümlicher Weise unter Artikel 11 und 13 der Satzung „Geschäfts-
führung“ und „Vertretung der Gesellschaft“ ein Fehler unterlaufen ist.

Die Erschienene berichtigt hiermit Artikel 11 und Artikel 13, dass diese richtigerweise wie folgt lauten sollen:

„ Art. 11. Geschäftsführung. Die Geschäfte der Gesellschaft werden, außer wenn es nur einen Alleingesellschafter gibt,

von mindestens zwei Geschäftsführern geführt, die einen Verwaltungsrat bilden.

Geschäftsführer müssen keine Gesellschafter der Gesellschaft sein. Wenn nur ein Geschäftsführer bestellt wurde, hat

dieser Einzelgeschäftsführer sämtliche Befugnisse des Verwaltungsrats.

Ihre Vergütung wird durch Beschluss der Gesellschafterversammlung mit einfacherer Mehrheit der abgegebenen Stim-

men oder (gegebenenfalls) durch den Alleingesellschafter festgesetzt. Die Vergütung der Geschäftsführer kann durch
Beschluss mit den gleichen Mehrheitsvoraussetzungen abgeändert werden.

Die Gesellschafterversammlung oder (gegebenenfalls) der Alleingesellschafter kann den/die Geschäftsführer jederzeit

und mit sofortiger Wirkung abberufen und ersetzen.

Werden mehrere Geschäftsführer bestellet, treffen sie ihre Entscheidungen im Rahmen von Verwaltungsratssitzungen.
Der Verwaltungsrat wählt aus der Mitte seiner Mitglieder einen Vorsitzenden, der im Falle von Stimmengleichheit bei

seiner Wahl kein Stimmrecht hat. Der Vorsitzende leitet alle Sitzungen des Verwaltungsrats. In Abwesenheit des Vorsi-
tzenden bestimmen die anderen Geschäftsführer einen Vorsitzenden pro tempore, der die entsprechende Sitzung leitet,
mit einfacher Stimmenmehrheit der bei der Sitzung anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer. Der Verwaltungsrat
kann einen Schriftführer, der kein Geschäftsführer sein muss, für die Anfertigung der Protokolle der Verwaltungsratssi-
tzungen oder andere vom Verwaltungsrat näher bezeichnete Aufgaben ernennen.

Der Verwaltungsrat trifft sich auf Einladung des Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern an dem in der Sitzung-

seinladung angegebenen Ort.

Einladungen zu Verwaltungsratssitzungen sind den Geschäftsführern mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor der

Sitzung zu übermitteln, es sei denn, es besteht ein Notfall oder besondere Dringlichkeit, welche im Sitzungsprotokoll
festzustellen sind.

Jede Einladung gibt Datum, Uhrzeit und Ort sowie den Gegenstand der Sitzung an.
Einladungen können durch jeden Geschäftsführer mündlich, schriftlich, per Fax, Telegramm, Email, Telex oder jedes

andere angemessene Kommunikationsmittel erfolgen.

Vor einer Einladung kann durch Zustimmung aller Geschäftsführer in schriftlicher Form oder per Fax, Email, Telex

oder jedes andere angemessene Kommunikationsmittel abgesehen werden.

Die Sitzung kann ohne vorherige Einladung abgehalten werden, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten

sind.

Eine separate Einladung ist nicht erforderlich für Sitzungen, deren Datum, Uhrzeit und Ort in einem vorherigen vom

Verwaltungsrat gefassten Beschluss bestimmt wurden.

Jeder Geschäftsführer kann sich bei Verwaltungsratssitzungen von einem anderen Geschäftsführer vertreten lassen,

wenn er diesen schriftlich oder per Fax, Telegramm, Email, Telex oder ein anderes angemessenes Kommunikationsmittel
bevollmächtigt hat.

Ein Geschäftsführer kann mehrere Geschäftsführer vertreten.
Die Geschäftsführer können an Verwaltungsratssitzungen per Telefon, Videokonferenz oder durch ein anderes ange-

messenes Kommunikationsmittel, das es allen an der Sitzung teilnehmenden Personen erlaubt, sich zur gleichen Zeit zu
hören, teilnehmen. Eine Verwaltungsratssitzung, die über derartige Kommunikationsmittel abgehalten wurde, gilt als in
Luxemburg abgehalten.

Der Verwaltungsrat ist nur beschluss- und handlungsfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder ver-

treten ist.

Die Teilnahme an Sitzungen über eines der vorgenannten Kommunikationsmittel steht einer persönlichen Teilnahme

an der Sitzung gleich.

Stimmabgaben können auch per Fax, Telegramm, Email, Telex oder jedes andere angemessene Kommunikationsmittel

erfolgen, vorausgesetzt, dass im letzten Fall die Stimmabgabe schriftlich oder per Fax, Telegramm, Email oder Telex
bestätigt wird.

135201

L

U X E M B O U R G

Entscheidungen des Verwaltungsrats werden mit einer Mehrheit der an der Sitzung teilnehmenden oder vertretenen

Geschäftsführer getroffen.

Die Beratungen des Verwaltungsrats werden in einem Protokoll festgehalten, das vom Vorsitzenden oder von zwei

(2) Geschäftsführern unterzeichnet wird. Jede Abschrift oder Auszug des Protokoll ist vom Vorsitzenden oder von zwei
(2) Geschäftsführern zu unterzeichnen.

Schriftliche Beschlüsse, denen alle Geschäftsführer zugestimmt haben und die von diesen unterzeichnet sind, stehen

auf einer Verwaltungsratssitzung gefassten Beschlüssen gleich.

In diesen Fällen, können schriftliche Beschlüsse entweder in einem einzelnen Dokument oder in mehreren Dokumen-

ten gleichen Inhalts dokumentiert werden.

Schriftliche Beschlüsse können durch normale Post, Fax, Telegramm, Email, Telex oder jedes andere angemessenen

Telekommunikationsmittel übermittelt werden.“

„ Art. 13. Vertretung der Gesellschaft. Die Gesellschaft wird durch die alleinige Unterschrift ihres Einzelgeschäftsfüh-

rers und, wenn es mehr als einen Geschäftsführer gibt, durch die gemeinschaftliche Unterschrift zweier Geschäftsführer
verpflichtet.“

Die Erschienene beantragt diese Berichtigung bei dem Firmenregister sowie in den Koordinierten Statuten einzutragen.

Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparentin, welche dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vor-

namen, Stand und Wohnort bekannt ist, hat dieselbe mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: A. München et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 29 juillet 2014. LAC/2014/35768. Reçu douze euros EUR 12,-

<i>Le Receveur (signée): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 août 2014.

Référence de publication: 2014127441/92.
(140144119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2014.

SPL S.A., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8011 Strassen, 281, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 173.593.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 7 août 2014.

Référence de publication: 2014127465/10.
(140143677) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2014.

SAB, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 19, Op der Ahlkerrech.

R.C.S. Luxembourg B 67.201.

Im Jahre zweitausendvierzehn, den neunundzwanzigsten Juli.
Vor dem unterzeichnenden Notar Paul BETTINGEN, mit Amtswohnsitze zu Niederanven,

Ist erschienen:

Die Aktiengesellschaft PROLUXRAIL S.A., mit Sitz in L-2014 Luxemburg, 18, avenue Marie-Thérèse, eingetragen im

Handels- und Firmenregister Luxemburg unter der Nummer B 53.664, hier vertreten durch Herrn Mario KRATZ, Kauf-
mann,  wohnhaft  in  D-54456  Tawern,  34,  Margareten  Str.  laut  einer  privatschriftlichen  Vollmacht,  welche  von  dem
Bevollmächtigten und dem unterzeichnenden Notar “ne varietur” gegengezeichnet wurde und dem Notarakt beigebogen
verbleibt.

Welche Erschienene, vertreten wie vorerwähnt, den instrumentierenden Notar ersucht, Folgendes zu beurkunden:
Die Erschienene, vorbenannt, ist alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft mit beschränkter Haftung SAB, G.m.b.H.,

mit Sitz in L-6776 Grevenmacher, 19, Op der Ahlkerrech, eingetragen im Handels- und Firmenregister Luxemburg unter
der Nummer B 67.201, gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch den Notar Jean-Joseph WAGNER, mit dem
Amtssitz in Sassenheim, handelnd in Vertretung des unterzeichnenden Notars, am 6. November 1998, veröffentlicht im
Mémorial C Nummer 70 vom 5. Februar 1999, letztmalig abgeändert durch Urkunde des unterzeichnenden Notars, vom
17. November 2010, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 1295 vom 22. Juni 2010.

135202

L

U X E M B O U R G

In ihrer Eigenschaft als alleinige Gesellschafterin erklärt die vorgenannte Erschienene, vertreten wie vorerwähnt, dem

instrumentierenden Notar, sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammenzufinden mit folgender Ta-
gesordnung:

<i>Tagesordnung

1. Erhöhung des Gesellschaftskapitals um zweihundertfünfzigtausend Euro (EUR 250.000,-), um es von seinem jetzigen

Stand von zweihundertfünfzigtausend Euro (EUR 250.000,-) auf fünfhunderttausend Euro (EUR 500.000,-) zu bringen,
ohne Schaffung von neuen Anteilen aber durch Erhöhung ihres buchhalterischen Pari.

2. Zeichnung und Einzahlung, durch Belastung des Ergebnisvortrages, durch den alleinigen Gesellschafter.
3. Abänderung von Artikel 6 der Satzungen.
4. Verschiedenes.
Gemäss der Tagesordnung hat die Erschienene, vertreten wie vorerwähnt, einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin beschliesst das Gesellschaftskapital um zweihundertfünfzigtausend Euro (EUR 250.000,-)

zu erhöhen, um es von seinem jetzigen Stand von zweihundertfünfzigtausend Euro (EUR 250.000,-) auf fünfhunderttausend
Euro (EUR 500.000,-) zu bringen, ohne Ausgabe von neuen Anteilen aber durch Erhöhung des buchhalterischen Pari der
vierhundertvierundachtzig (484) bestehenden Anteile.

<i>Zeichnung und Einzahlung der Anteile

Die Kapitalerhöhung wird gezeichnet durch die alleinige Gesellschafterin PROLUXRAIL S.A., vorbenannt und vertreten

wie vorerwähnt. Die Summe dieser Erhöhung von zweihundertfünfzigtausend Euro (EUR 250.000,-) wurde dem Kapital
durch Belastung des Ergebnisvortrages der Gesellschaft zugeführt. Die Existenz des Ergebnisvortrages wurde durch die
Bilanzübersicht zum 31. Dezember 2013 nachgewiesen. Eine Kopie dieser Bilanzübersicht bleibt diesem Protokoll beige-
fügt  und  wird  gemeinsam  mit  diesem  Protokoll  bei  der  zuständigen  Behörde  zwecks  Registrierung  eingereicht.  Der
Delegierte des Verwaltungsrates, Herrn Roland EBSEN, Buchhalter, wohnhaft in L-6745 Grevenmacher, 12, Kuschegässel,
bescheinigt hiermit, dass den Ergebnisvortrag am heutigen Tage verfügbar ist, welche Bescheinigung gegenwärtiger Ur-
kunde nach „ne varietur«Unterzeichnung beigefügt bleibt.

<i>Zweiter Beschluss

Infolge vorangehender Kapitalerhöhung werden die gesamten vierhundertvierundachtzig (484) Anteile durch die Ak-

tiengesellschaft PROLUXRAIL S.A. gehalten.

<i>Dritter Beschluss

Infolge der vorangehenden Beschlüsse beschliesst die alleinige Gesellschafterin Artikel 6 der Satzung wie folgt abzuän-

dern:

„ Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfhunderttausend Euro (EUR 500.000,-), eingeteilt in vierhundertvierun-

dachtzig (484) Anteile ohne Nennwert, alle vollständig gezeichnet und voll eingezahlt.“

Die Kosten welche der Gesellschaft wegen der gegenwärtigen Urkunde obliegen, werden auf eintausendsechshundert

Euro (EUR 1.600,-) abgeschätzt.

<i>Bevollmächtigung

Die Erschienenen, handelnd in gemeinsamem Interesse, erteilen hiermit einem jeden Angestellten des unterzeichneten

Notars Spezialvollmacht, in ihrem Namen jegliche etwaige Berichtigungsurkunde gegenwärtiger Urkunde aufzunehmen.

Worüber Urkunde, Aufgenommen zu Senningerberg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, Vornamen, Zivilstand und

Wohnort bekannt, hat derselbe mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Mario Kratz, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 29 juillet 2014. LAC / 2014 / 35781. Reçu 75.-€

<i>Le Receveur (signé): Irène Thill.

- Für gleichlautende Kopie - Ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, den 5. August 2014.

Référence de publication: 2014127444/68.
(140144022) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2014.

135203

L

U X E M B O U R G

Ideal Standard International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1748 Luxembourg-Findel, 4, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 160.198.

<i>I. Extrait des résolutions prises par l’actionnaire unique de la Société en date du 9 juin 2014

En dates du 9 juin 2014, l’actionnaire unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- d'accepter les démissions de Messieurs Walid SARKIS, David HAMILL, Gary CLEAVER et Steven BARNES de leur

mandat d'administrateur de la Société avec effet au 9 juin 2014;

- de nommer Monsieur Aaron ROSENSTEIN, né le 17 août 1980 à New York, Etats-Unis d'Amérique, résidant pro-

fessionnellement à l’adresse suivante: 101 St. Martin's Lane, 5 

th

 Floor, WC2N 4AZ Londres, Royaume-Uni en tant que

nouvel administrateur de la Société avec effet au 9 juin 2014 et ce pour une durée indéterminée;

- de nommer Monsieur Joao MARGARIDO, né le 26 juin 1975 à Rossio Ao Sul do Tejo Abrantes, Portugal résidant

professionnellement à l’adresse suivante: 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg en tant que nouvel adminis-
trateur de la Société avec effet au 9 juin 2014 et ce pour une durée indéterminée;

-  de  nommer  Monsieur  Hugo  FROMENT,  né  le  22  février  1974  à  Laxou,  France,  résidant  professionnellement  à

l’adresse suivante: 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg en tant que nouvel administrateur de la Société avec effet
au 9 juin 2014 et ce pour une durée indéterminée.

<i>II. Extrait des résolutions prises par l’actionnaire unique de la Société en date du 17 juillet 2014

En date du 17 juillet 2014, l’actionnaire unique de la Société a pris la résolution de limiter la durée du mandat des

personnes suivantes pour une durée déterminée jusqu'à l’assemblée générale de la Société qui statuera sur les comptes
de l’exercice clos au 31 décembre 2018:

- Monsieur Aaron ROSENSTEIN, administrateur
- Monsieur Joao MARGARIDO, administrateur
- Monsieur Hugo FROMENT, administrateur
Le conseil d'administration est désormais composé comme suit:
- Madame Ruth SPRINGHAM
- Monsieur Ed HAN
- Monsieur Aurélien VASSEUR
- Monsieur Aaron ROSENSTEIN
- Monsieur Joao MARGARIDO
- Monsieur Hugo FROMENT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 août 2014.

Ideal Standard International S.A.
Signature

Référence de publication: 2014127920/38.
(140145106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2014.

Renson &amp; Associates Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4960 Clemency, 2, rue de Bascharage.

R.C.S. Luxembourg B 159.941.

L'an deux mille quatorze, le vingt-deux juillet.
Par-devant Maître Patrick SERRES, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1) Monsieur Yves RENSON, demeurant au 4, Chemin de Wayai à B-4140 Sprimont;
2) Monsieur Franz Laurent RENSON, demeurant au 14, rue de Méry à B-4140 Dolembreux;
3) Monsieur Franz RENSON, demeurant au 52, rue de Henné à B-4053 Embourg;
ici représentés par Monsieur Louis Felicetti, salarié, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu de trois (3) procurations lui données à Luxembourg, le 24 juin 2014.
Lesquelles procurations, après avoir été signées «ne varietur»
les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

135204

L

U X E M B O U R G

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, déclarent être les seuls et uniques associés de la société à

responsabilité limitée Renson &amp; Associates S.à r.l., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 25, Boulevard Prince
Henri,

constituée suivant acte notarié du 2 mars 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro

1266 du 10 juin 2011.

Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500.-EUR), divisé en cent (100) parts sociales de cent vingt-

cinq euros (125.- EUR) chacune.

Lesdits comparants se sont ensuite réunis en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils déclarent avoir été

régulièrement convoqués et ont pris à l’unanimité et sur ordre du jour conforme les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de transférer avec effet immédiat le siège social de la société à L-4960 Clemency, 2, rue

de Bascharage.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 5, première phrase, des statuts en conséquence qui aura la teneur

suivante:

Art. 5. (première phrase). Le siège social est établi dans la commune de «Käerjeng».

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation en langue du pays aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état

et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: L. FELICETTI, Patrick SERRES.
Enregistré à Remich, le 25 juillet 2014. Relation: REM/2014/1634. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): P. MOLLING.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations

Remich, le 8 août 2014.

Référence de publication: 2014128158/41.
(140144415) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2014.

PHV. s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8378 Kleinbettingen, 1, rue du Chemin de Fer.

R.C.S. Luxembourg B 143.245.

DISSOLUTION

L’an deux mil quatorze, le vingt-huit juillet,
Par-devant Maître Camille MINES, notaire de résidence à Capellen,

Ont comparu:

Monsieur Philippe HENROTIN, sans profession, né à Kamina, RD Congo, le 14 février 1951, demeurant à E-03730

JAVEA/XABIA, Espagne, 12, Carrere Pic d’Espada, Buzon 5053, et

Madame Véronique MONIN, employée privée, née à Aye, Belgique, le 2 septembre 1968, demeurant à B-5100 Jambes,

106, avenue Bourgmestre Jean Materne.

Lesquels ont déclaré:
Qu’ensemble ils sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée PHV s.à r.l. avec siège à Kleinbettingen,

constituée par acte du notaire instrumentaire en date du 18 novembre 2008, publié au Mémorial C numéro 2943 du 11
décembre 2008, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 143245 et dont les statuts n’ont
pas encore été modifiés.

Que la société a cessé toute activité commerciale.
Que les comptes sociaux sont parfaitement connus des associés et sont approuvés par eux.
Que tout le passif de la société a été apuré et que tout l’actif a été distribué aux associés.
Que les associés n’ont plus de revendication envers la société.
Ceci approuvé, les comparants ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
1. La société PHV s.à r.l. est dissoute et liquidée avec effet immédiat.
2. Pour autant que de besoin, Monsieur Philippe HENROTIN, préqualifié, est à considérer comme liquidateur, qui est

également personnellement et solidairement avec les associés responsables des frais des présentes.

135205

L

U X E M B O U R G

3. Les documents de la société seront conservés pendant un délai de cinq ans à B-5100 Jambes, 106, avenue Bourg-

mestre Jean Materne.

4. Au cas où, par impossible, une dette ou une créance aurait échappé au liquidateur, les associés susdits en suppor-

teraient les frais ou en feraient le bénéfice.

Dont acte, fait et passé à Capellen, en l’étude du notaire instrumentant.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède aux comparants, connus du notaire par nom,

prénom, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: P. HENROTTIN, V. MONIN, C. MINES.
Enregistré à Capellen, le 30 juillet 2014. Relation: CAP/2014/2966. Reçu soixante-quinze euros 75,-€.

<i>Le Receveur (signé): I. Neu.

Pour copie conforme,

Capellen, le 7 août 2014.

Référence de publication: 2014128125/40.
(140144764) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2014.

Sixth Dimension S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 150.759.

<i>Extract of resolutions taken at the Annual General Meeting held exceptionally on July 17, 2014

1. The following mandates as Directors are renewed for a term of three years until the Annual General Meeting of

2017

Mr. Serge KRANCENBLUM, professionally residing at 412F, route d'Esch L-2086 Luxembourg
Mr. Harald CHARBON, professionally residing at 412F, route d'Esch L-2086 Luxembourg
Mr. Jeffrey A. SACKS, professionally residing PMB 322,3223 Lake Ave. Unit 15C, Wilmette, 1L 60091, USA
2. The mandate of the Company RSM Audit Luxembourg S. à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembour-

geois, with registered office at 6, rue Adolphe L-1116 Luxembourg as Independent Auditor is renewed for a term of one
year, until the Annual General Meeting of the year 2015.

Certified true

Suit la traduction française

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire tenue exceptionnellement le 17 juillet 2014

1. Les mandats d'Administrateurs suivants sont reconduits pour une nouvelle période de trois ans jusqu'à l'Assemblée

Générale Statutaire de l'an 2017:

M. Serge KRANCENBLUM, résident professionnellement au 412F, route d'Esch L-2086 Luxembourg
M. Harald CHARBON, résident professionnellement au 412F, route d'Esch L-2086 Luxembourg
M. Jeffrey A. SACKS, résident professionnellement PMB 322, 3223 Lake Ave. Unit 15C, Wilmette, IL 60091, USA
2. Le mandat de Réviseur d'Entreprises Agréé de la société RSM Audit Luxembourg S. à r.l., société à responsabilité

limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social est 6, rue Adolphe L-1116 Luxembourg est renouvelé pour une
période de 1 an, jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2015.

Certifié exact et sincère
SIXTH DIMENSION S.A.
Signatures
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2014128230/31.
(140144811) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2014.

Sources &amp; Trades Technology Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 189.273.

1. Suite à la cession de parts intervenue en date du 07 août 2014 entre International Pyramide Holdings (Luxembourg)

S.A. et Sources &amp; Trades Technology Holdings GmbH, 1,250,000 parts sociales de la Société sont transférées comme
suit:

135206

L

U X E M B O U R G

a. international Pyramide Holdings (Luxembourg) S.A, une société anonyme, ayant son siège social au 46A, Avenue

John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B
46448, cède 1,250,000 parts sociales qu'elle détient dans la Société avec effet au 08 août 2014 et ne détient désormais
aucune part sociale de la Société;

b. Sources &amp; Trades Technology Holdings GmbH, une société limitée, ayant son siège social sis à Meier Partner Tax

AG, au 11, Grienbachstrasse, à Zug, CH-6300, en Suisse, et immatriculée au Commercial Register à Zug sous le numéro
CHE  -412.398.757,  acquiert  1,250,000  parts  sociales  de  la  Société  avec  effet  au  08  août  2014  et  détient  désormais
1,250,000 parts sociales de la Société.

2. En date du 08 août 2014 l'associé unique de la Société a pris les décisions suivantes:
2.1 Election d'un nouveau gérant de catégorie A, à compter du 08 août 2014 pour une durée indéterminée:
- M. Peter Johan R. Reygel, né le 04 février 1963, à Hasselt, en Belgique, pour adresse professionnelle 1a, Wylenstrasse,

CH 6440, Ingenbohl, Suisse;

2.2 Reclassement de Manacor (Luxembourg) S.A en qualité de gérant B de la Société, à compter du 08 août 2014 pour

une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SOURCES &amp; TRADES Technology Services S.à r.l.
Représentée par Manacor (Luxembourg) S.A.
Signatures
<i>Gérant B

Référence de publication: 2014128242/30.
(140144718) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2014.

Beim Engelchen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6560 Hinkel, 3, Ennescht Dueref.

R.C.S. Luxembourg B 95.280.

DISSOLUTION

L'an deux mille quatorze, le trente-et-un juillet.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

ONT COMPARU:

Mademoiselle Patricia ENGEL, cabaretière, née à Luxembourg, le 21 novembre 1964, demeurant à L-6560 Hinkel, 3,

Ennescht Dueref.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit sa déclaration:
1.- Que la comparante est la seule et unique associée de la société à responsabilité limitée «Beim Engelchen S.à r.l.»,

avec siège social à L-6560 Hinkel, 3, Ennescht Dueref, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
section B, sous le numéro 95.280, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 23 septembre
2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, numéro 1584 du 5 novembre 2002, dont les statuts
ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 8 janvier 2010, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 613 du 5 novembre 2002.

2.- Que le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) divisé en cent (100) parts sociales de

cent vingt-cinq Euros (EUR 125,-) chacune.

3.- Que la comparante prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat.
4.- Que la comparante se désigne comme liquidateur de la Société et auront pleins pouvoirs d'établir, signer, exécuter

et délivrer tous actes et documents, de faire toute déclaration et de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour mettre
en exécution les dispositions du présent acte.

5.- Que la comparante est investie de tous les éléments actifs de la Société et répondront personnellement de tout le

passif social et de tous les engagements de la société même inconnus à ce jour.

6.- Que la comparante déclare qu'elle reprend tout l'actif de la Société et qu'elle s'engagera à régler tout le passif de

la Société indiqué à la section 5.

7.- Que la comparante déclare que la liquidation de la Société est clôturée et que tous les registres de la Société relatifs

à l'émission de parts sociales ou de tous autres titres seront annulés.

8.- Que décharge est donnée à la gérante de la Société.
9.- Que les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq ans au moins à L-6560 Hinkel, 3, Ennescht

Dueref.

135207

L

U X E M B O U R G

<i>Frais

Tous les frais et honoraires résultant du présent acte, évalués à huit cent cinquante euros, sont à charge de la société

dissoute.

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Patricia ENGEL, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 11 août 2014. Relation GRE/2014/3220. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2014128443/44.
(140145613) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2014.

Bull &amp; Bear Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 165.639.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014128446/10.
(140146175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2014.

Highstreet Propco II s.à R.L., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 35.000,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 189.192.

In the year two thousand and fourteen, on the eleventh day of August.
Before, Maître Martine DECKER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, acting in replacement

of Maître Edouard DELOSCH, notary residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg, which last will remain the
depositary of the present deed,

THERE APPEARED:

Corestate HIGHSTREET HoldCo S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the

laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of one hundred thousand Euro (EUR 100,000.-), whose
registered office is at 35, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, and in the process of registration with the Luxembourg
Register of Commerce and Companies (the “Sole Shareholder”),

hereby represented by Maître Patrick Chantrain, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy

given on 8 August 2014.

The above mentioned proxy, signed by the appearing person and the undersigned notary, shall remain annexed to the

present deed.

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record that the Sole Shareholder is the sole shareholder

of HIGHSTREET PropCo II S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of
the Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), whose
registered office is at 35, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following
a deed of Maître Edouard DELOSCH, notary residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg, of 30 July 2014, not yet
published  in  the  Mémorial  C,  Recueil  des  Sociétés  et  Associations  and  registered  with  the  Luxembourg  Register  of
Commerce and Companies under number B 189192 (the “Company”). The articles of association of the Company have
for the last time been amended following a deed of Maître Francis KESSELER, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand
Duchy of Luxembourg, acting in replacement of Maître Edouard DELOSCH, notary residing in Diekirch, Grand Duchy
of Luxembourg, of 8 August 2014, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The Sole Shareholder, represented as above mentioned, has recognised to be duly and fully informed of the resolutions

to be taken on the basis of the following agenda:

<i>Agenda

1. To increase the corporate capital of the Company by an amount of EUR 22,500.- (twenty-two thousand five hundred

Euro) so as to raise it from its present amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) to EUR 35,000.-
(thirty-five thousand Euro).

135208

L

U X E M B O U R G

2. To issue 22,500 (twenty-two thousand five hundred) new shares having a par value of EUR 1.- (one Euro) each,

having the rights and privileges as those set out in the Company's articles of association.

3. To accept the subscription of the newly issued 22,500 (twenty-two thousand five hundred) shares in consideration

for a contribution in cash.

4. To set the amount of the Company's share capital at EUR 35,000.- (thirty-five thousand Euro) represented by 35,000

(thirty-five thousand) shares having a par value of EUR 1.- (one Euro) each.

5. Amendment of article 5 of the articles of association of the Company.
6. Miscellaneous.
The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolved to increase the corporate capital of the Company by an amount of EUR 22,500.-

(twenty-two thousand five hundred Euro) so as to raise it from its present amount of EUR 12,500.-(twelve thousand five
hundred Euro) to EUR 35,000.- (thirty-five thousand Euro).

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolved to issue 22,500 (twenty-two thousand five hundred) new shares having a par value of

EUR 1.- (one Euro) each, having the rights and privileges as those set out in the Company's articles of association.

<i>Subscription - Payment

Thereupon appeared the Sole Shareholder, aforementioned, represented by Maître Patrick Chantrain, by virtue of the

aforementioned proxy, signed by the proxyholder and the undersigned notary, which will remain annexed to the present
deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The Sole Shareholder declared to subscribe for all 22,500 (twenty-two thousand five hundred) new shares, each share

having a par value of EUR 1.- (one Euro) and to fully pay in cash for these new shares.

The aggregate amount of EUR 22,500.- (twenty-two thousand five hundred Euro) was thus as from that moment at

the disposal of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.

<i>Third resolution

The Sole Shareholder resolved to accept said subscription and payment and to allot the 22,500 (twenty-two thousand

five hundred) new shares as fully paid in shares to the Sole Shareholder.

<i>Fourth resolution

The Sole Shareholder resolved to set the amount of the corporate capital of the Company at EUR 35,000.- (thirty-

five thousand Euro) represented by 35,000 (thirty-five thousand) shares having a par value of EUR 1.- (one Euro) each as
well as the rights and privileges as those set out in the Company's articles of association.

<i>Fifth resolution

The Sole Shareholder resolved to amend article 5 of the articles of association of the Company which shall henceforth

read as follows:

“ Art. 5. Share capital. The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 35,000.- (thirty-five thousand Euro),

represented by 35,000 (thirty-five thousand) shares having a par value of EUR 1.- (one Euro) per share each.”

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed, are estimated at approximately EUR 1,100.- (one thousand one hundred Euro).

WHEREOF, the present deed was drawn up in Hesperange-Howald, on the day named at the beginning.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a German version; at the request of the same appearing party
and in case of divergences between the English and German texts, the English version shall prevail.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by its surname, first name, civil

status and residence, the said person signed together with the notary this original deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendvierzehn, am elften Tag des Monats August.
Vor Maître Martine DECKER, Notar mit Amtswohnsitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, welcher Maître

Edouard DELOSCH, Notar mit Amtswohnsitz in Diekirch, Großherzogtum Luxemburg in dessen Abwesenheit vertritt,
welch letztgenannter der Bewahrer der vorliegenden Urkunde bleiben wird.

IST ERSCHIENEN,

135209

L

U X E M B O U R G

Corestate HIGHSTREET HoldCo S.à r.l. ist, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité

limitée) unterliegend dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit einem Gesellschaftskapital in Höhe von einhun-
derttausend Euro (EUR 100.000,-), mit Gesellschaftssitz in 35, avenue Monterey, L-2163 Luxemburg, Großherzogtum
Luxemburg, und im Registrierungsprozess beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg (die „Alleingesellschafte-
rin“),

hier  vertreten  durch  Maître  Patrick  Chantrain,  mit  Berufsanschrift  in  Luxemburg,  aufgrund  einer  Vollmacht  unter

Privatschrift, ausgestellt am 8. August 2014.

Vorbezeichnete Vollmacht wird nach Unterzeichnung ne varietur durch die erschienene Person und den Notar dieser

Urkunde als Anlage beigefügt bleiben.

Die Alleingesellschafterin hat den amtierenden Notar gebeten, zu beurkunden, dass die Alleingesellschafterin die al-

leinige Gesellschafterin der HIGHSTREET PropCo II S.à r.l. ist, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à
responsabilité limitée) unterliegend dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit einem Gesellschaftskapital in Höhe
von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), mit Gesellschaftssitz in 35, avenue Monterey, L-2163 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg, gegründet gemäß Urkunde erstellt durch Maître Edouard DELOSCH, Notar mit Amtssitz
in Diekirch, Großherzogtum Luxemburg, vom 30. Juli 2014, noch nicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions veröffentlicht und eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 189192 (die
„Gesellschaft“). Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt abgeändert gemäß Urkunde, erstellt durch Maître Francis
KESSELER, Notar mit Amtssitz in Esch-sur-Alzette, Großherzogtum Luxemburg, welcher Maître Edouard DELOSCH,
Notar mit Amtssitz in Diekirch, Großherzogtum Luxemburg, in dessen Abwesenheit vertrat, vom 8. August 2014, noch
nicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht.

Die Alleingesellschafterin, wie vorstehend vertreten, erkennt ausdrücklich an, von den aufgrund der folgenden Tages-

ordnung zu fassenden Beschlüssen umfassende Kenntnis gehabt zu haben:

<i>Tagesordnung

1. Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft um einen Betrag in Höhe von EUR 22.500,- (zweiundzwanzig-

tausendfünfhundert Euro), um dieses von seinem derzeitigen Betrag in Höhe von EUR 12.500,- (zwölftausendfünfhundert
Euro) auf EUR 35.000,-(fünfunddreißigtausend Euro) zu bringen.

2. Schaffung von 22.500 (zweiundzwanzigtausendfünfhundert) neuen Anteilen mit einem Nennwert von je EUR 1,- (ein

Euro), die die gleichen Rechte und Privilegien haben, wie in der Satzung der Gesellschaft beschrieben.

3. Annahme der Zeichnung der neu geschaffenen 22.500 (zweiundzwanzigtausendfünfhundert) Anteile gegen Barein-

lage.

4. Festsetzen des Kapitals der Gesellschaft auf EUR 35.000,- (fünfunddreißigtausend Euro), eingeteilt in 35.000 (fünf-

unddreißigtausend) Anteile mit einem Nennwert von je EUR 1,-(ein Euro).

5. Änderung von Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft.
6. Verschiedenes.
Die Alleingesellschafterin hat den amtierenden Notar gebeten folgende Beschlussfassungen aufzunehmen:

<i>Erster Beschluss

Die Alleingesellschafterin hat beschlossen, das Kapital der Gesellschaft um einen Betrag in Höhe von EUR 22.500,-

(zweiundzwanzigtausendfünfhundert  Euro)  zu  erhöhen,  um  dieses  von  seinem  derzeitigen  Betrag  in  Höhe  von  EUR
12.500,-(zwölftausendfünfhundert Euro) auf EUR 35.000,- (fünfunddreißigtausend Euro) zu bringen.

<i>Zweiter Beschluss

Die Alleingesellschafterin hat beschlossen, 22.500 (zweiundzwanzigtausendfünfhundert) neue Anteile mit einem Nenn-

wert  von  je  EUR  1,-  (ein  Euro)  und  mit  den  gleichen  Rechten  und  Privilegien,  wie  in  der  Satzung  der  Gesellschaft
beschrieben, zu schaffen.

<i>Zeichnung - Einzahlung

Daraufhin erschien die Alleingesellschafterin, wie eingangs bezeichnet, vertreten durch Maître Patrick Chantrain, durch

die vorbezeichnete Vollmacht, welche durch den Bevollmächtigten und den amtierenden Notar unterzeichnet und dieser
Urkunde beiliegen bleibt und zusammen mit ihr zur Registrierung eingereicht werden wird.

Die Alleingesellschafterin gab an, sämtliche 22.500 (zweiundzwanzigtausendfünfhundert) neue Anteile mit einem Nenn-

wert von je EUR 1,- (ein Euro) zu zeichnen und diese neuen Anteile mittels Bareinlage voll einzuzahlen.

Der Gesamtbetrag in Höhe von EUR 22.500,-(zweiundzwanzigtausendfünfhundert Euro) stand fortan der Gesellschaft

zur Verfügung. Ein Beweis hierfür wurde dem amtierenden Notar vorgelegt.

<i>Dritter Beschluss

Die  Alleingesellschafterin  hat  beschlossen,  vorbezeichnete  Zeichnung  und  Einzahlung  anzunehmen  und  die  22.500

(zweiundzwanzigtausendfünfhundert) neuen Anteilen als voll einbezahlte Anteile der Alleingesellschafterin zuzuweisen.

135210

L

U X E M B O U R G

<i>Vierter Beschluss

Die Alleingesellschafterin hat beschlossen, das Kapital der Gesellschaft auf EUR 35.000,- (fünfunddreißigtausend Euro),

eingeteilt in 35.000 (fünfunddreißigtausend) Anteile mit einem Nennwert von je EUR 1,- (ein Euro), die die in der Satzung
der Gesellschaft beschrieben Rechte und Privilegien haben, festzusetzen.

<i>Fünfter Beschluss

Die Alleingesellschafterin hat beschlossen, Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft abzuändern, um nunmehr wie folgt

zu lauten:

„ Art. 5. Kapital der Gesellschaft. Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 35.000,- (fünfunddreißigtausend Euro), eingeteilt

in 35.000 (fünfunddreißigtausend) Anteile mit einem Nennwert von je EUR 1,- (ein Euro) pro Anteil.“

<i>Kosten

Die Kosten und Auslagen, die der Gesellschaft in Zusammenhang mit vorliegender Urkunde entstehen oder die sie zu

tragen hat, belaufen sich auf ungefähr EUR 1.100,- (eintausend einhundert Euro).

WORÜBER Urkunde erstellt in Hesperange-Howald am Datum, wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnete Notar, der der englischen Sprache mächtig ist, erklärt hiermit, dass auf Ersuchen der erschienenen

Partei diese Urkunde in englischer Sprache verfasst und mit einer deutschen Übersetzung versehen ist und dass im Falle
einer Abweichung des englischen vom deutschen Text der englische Text maßgebend ist.

Nachdem die Urkunde der erschienenen Person, welche dem Notar mit Nachname, Vorname, Personenstand und

Adresse bekannt ist, vorgelesen wurde, hat die erschienene Person zusammen mit dem Notar die vorliegende Urkunde
unterschrieben.

Gezeichnet: P. CHANTRAIN, M. DECKER.
Enregistré à Diekirch, le 13 août 2014. Relation: DIE/2014/10327. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

<i>Le Receveur (signé): Recken.

Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Begehr erteilt.

Diekirch, den 14. August 2014.

Référence de publication: 2014130682/166.
(140147784) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2014.

Immobilière Saint Marcel S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 99.814.

<i>Assemblée générale extraordinaire du 28/07/2014.

Une assemblée générale extraordinaire s'est tenue à 10h00 le 28 juillet 2014 au siège de la société Immobilière Saint

Marcel SA, à Luxembourg, 21-25, Allée Scheffer.

Les décisions suivantes ont été prises:

<i>Résolution - Démissions des administrateurs et commissaires aux comptes et nomination de nouveaux administrateurs et d'un

<i>nouveau commissaire aux comptes

L'assemblée des actionnaires de la société Immobilière Saint Marcel SA a pris à la majorité des voix, soit avec 23 votes

pour (65,7142 % des voix de tous les actionnaires), aucun votre contre, la décision d'accepter la démission du 28.12.2012
de l'administrateur INVESTOR'S BUSINESS OFFICE S.A., avec siège social à L-1941 Luxembourg, 261 route de Longwy
et immatriculée au Registre de Commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro RC B 78554.

L'assemblée des actionnaires de la société Immobilière Saint Marcel SA a pris à la majorité des voix, soit avec 23 votes

pour (65,7142 % des voix de tous les actionnaires), aucun votre contre, la décision d'accepter la démission du 28.12.2012
de l'administrateur Marga MENGATO, demeurant à L-3236 Bettembourg, 20 rue de la Gare, née le 30.07.1982 à Esch-
sur-Alzette (Luxembourg).

L'assemblée des actionnaires de la société Immobilière Saint Marcel SA a pris à la majorité des voix, soit avec 23 votes

pour (65,7142 % des voix de tous les actionnaires), aucun votre contre, la décision de révoquer l'administrateur Said EL
GOURARI, demeurant à L-1466 Luxembourg, 6 rue Jean Engling, né le 14.4.1975 à Woippy (France).

L'assemblée des actionnaires de la société Immobilière Saint Marcel SA a pris à la majorité des voix, soit avec 23 votes

pour (65,7142 % des voix de tous les actionnaires), aucun votre contre, la décision d'accepter la démission du 24/05/2012
du commissaire aux comptes Breckewee S.àr.l, établi à L-8561 Schwebach, 1 Haaptstrooss, immatriculée au Registre de
Commerce et des sociétés à Luxembourg, sous le numéro RC B 157331.

L'assemblée des actionnaires de la société Immobilière Saint Marcel SA a pris à la majorité des voix, soit avec 23 votes

pour (65,7142 % des voix de tous les actionnaires), aucun votre contre, la décision de nommer Monsieur Jean-Louis

135211

L

U X E M B O U R G

Bonet-Maury, médecin, demeurant à F-76810 GREUVILLE (France), 130 rue de la Grande Mare, né le 16 mars 1954 à
Paris (France) pour une durée de 6 (six) ans au poste d'administrateur de la société Immobilière Saint Marcel SA. Le
mandat d'administrateur commence le 28/07/2014 et se terminera lors de l'assemblée générale ordinaire de l'année 2020
qui statuera sur les comptes annuels de l'année 2019.

L'assemblée des actionnaires de la société Immobilière Saint Marcel SA a pris à la majorité des voix, soit avec 23 votes

pour (65,7142 % des voix de tous les actionnaires), aucun votre contre, la décision de nommer Monsieur Olivier BONET-
MAURY SCHALLER, administrateur de sociétés, demeurant à F-76740 Saint Aubin sur Mer, Villa «Les Hêtres», 33 rue
de l'Isolette, né le 26 mars 1958 à Travers (Suisse) pour une durée de 6 (six) ans au poste d'administrateur de la société
Immobilière Saint Marcel SA. Le mandat d'administrateur commence le 28/07/2014 et se terminera lors de l'assemblée
générale ordinaire de l'année 2020 qui statuera sur les comptes annuels de l'année 2019.

L'assemblée des actionnaires de la société Immobilière Saint Marcel SA a pris à la majorité des voix, soit avec 23 votes

pour (65,7142 % des voix de tous les actionnaires), aucun votre contre, la décision de nommer Madame Nicole BONET-
MAURY, retraitée, demeurant à F-76740 Saint Aubin sur Mer, Villa «Les Hêtres», 33 rue de l'Isolette, née le 23 octobre
1927 à Paris (8è) (France) pour une durée de 6 (six) ans au poste d'administrateur de la société Immobilière Saint Marcel
SA. Le mandat d'administrateur commence le 28/07/2014 et se terminera lors de l'assemblée générale ordinaire de l'année
2020 qui statuera sur les comptes annuels de l'année 2019.

L'assemblée des actionnaires de la société Immobilière Saint Marcel SA a pris à la majorité des voix, soit avec 23 votes

pour (65,7142 % des voix de tous les actionnaires), aucun votre contre, la décision de nommer la société DANA SERVICES
S.àr.l, établie à L-7540 Lintgen, 9 rue de Diekirch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro RC B 71643, au poste de commissaire aux comptes de la société Immobilière Saint Marcel SA. Le mandat de
commissaire aux comptes commence le 28/07/2014 et se terminera lors de l'assemblée générale ordinaire de l'année
2020 qui statuera sur les comptes annuels de l'année 2019.»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LE 28 JUILLET 2014.

POUR EXTRAIT CONFORME
Jean-Louis Bonet-Maury / Olivier Bonet-Maury / Claude Karp
<i>Président / Scrutateur / Secrétaire

Référence de publication: 2014130698/57.
(140148286) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2014.

Immoparko S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 29.961.

L'an deux mille quatorze, le cinq août,
Par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit

une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme IMMOPARKO S.A. ayant son siège

social 241, route de Longwy, L-1941 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous section B numéro 29961, constituée suivant acte notarié reçu en date du 5 janvier 1989 publié au Mémorial C,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations (ci-après le «Mémorial C») numéro 158 du 8 juin 1989; et dont les statuts
ont été modifiés pour la dernière fois suivante acte reçu par Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg,
Grand Duché de Luxembourg le 13 novembre 2001 publié au Mémorial C numéro 471 du 25 mars 2002.

L'assemblée est présidée par Sara Lecomte, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur François Differdange, administrateur

de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les trente mille (30.000) actions, représentant l'intégralité du

capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1.- Décision de la mise en liquidation volontaire de la société.
2.-Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.

135212

L

U X E M B O U R G

3.- Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
IV.- L'intégralité du capital social étant représentée à la présente l'Assemblée, les Actionnaires décident de renoncer

aux formalités de convocation.

Les actionnaires acceptent dès lors de délibérer et de voter les points portés à l'ordre du jour. Ils confirment que

toute la documentation présentée lors de l'assemblée a été mise à leur disposition endéans une période suffisante pour
leur permettre d'examiner attentivement chaque document.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de la mise en liquidation de la société avec effet immédiat.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de nommer en tant que liquidateur, Monsieur Andréa STEFANINA, né le 17 février 1952 à Brescia

(Italie), demeurant Vila De Santa Ihla do Sal (République du Cap Vert).

Le liquidateur prénommé a la mission de réaliser tout l'actif et apurer le passif de la société. Dans l'exercice de sa

mission, le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et il peut se référer aux écritures de la société. Le liquidateur
pourra sous sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs
à un ou plusieurs mandataires. Le liquidateur pourra engager la société en liquidation sous sa seule signature et sans
limitation. Il dispose de tous les pouvoirs tels que prévus à l'article 144 de la loi sur les sociétés commerciales, ainsi que
de tous les pouvoirs stipulés à l'article 145 de ladite loi, sans avoir besoin d'être préalablement autorisé par l'assemblée
générale des actionnaires.

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide de donner décharge pleine et entière aux administrateurs et au Commissaire aux comptes pour

l'exécution de leur mandat jusqu'à la date du présent acte.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille euros (EUR 1.000,-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: S. LECOMTE, F. DIFFERDANGE, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils le 7 août 2014. Relation: LAC/2014/37523. Reçu douze euros (EUR 12,-).

<i>Le Receveur

 (signé): C. FRISING.

Référence de publication: 2014130699/61.
(140147890) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2014.

Interactive Creatures Environment Limited S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-9016 Ettelbruck, 3, rue de l'Ecole Agricole.

R.C.S. Luxembourg B 165.981.

En date du 19 mai 2014 ont eu lieu les cessions de parts sociales suivantes:
Madame Yvonne FABER-THILLENS a cédé 5 (cinq) parts sociales qu'elle détenait à Monsieur Francis FABER.
Monsieur Claude PEIFFER, a cédé 5 (cinq) parts sociales qu'il détenait à Monsieur Francis FABER.
Madame  Yvonne  ZEIMEN-NICOLAI,  a  cédé  5  (cinq)  parts  sociales  qu'elle  détenait  à  Madame  Nicole  ZEIMEN-

SCHMITZ.

Madame Liliane NICOLAI-SCHLUNGS a cédé 5 (cinq) parts sociales qu'elle détenait à Mr Alain NICOLAI.
Au terme de ces cessions de parts sociales, la répartition du capital de la société est la suivante:

Goal Reach Trading 57 cc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 parts sociales
Mr Francois FABER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 parts sociales
Monsieur Nico FAUST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 parts sociales
The JOAL Share Trust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 parts sociales
Madame Nicole ZEIMEN-SCHMITZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 parts sociales
Monsieur Alain NICOLAI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 parts sociales
Monsieur Romain TRANCHIDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 parts sociales

135213

L

U X E M B O U R G

Monsieur Cary ARENDT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 parts sociales
Madame Marie Louise REINARDT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 parts sociales
Madame Nathalie DRAUT-FAUST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 parts sociales
Dr. Ulrich JAGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 parts sociales
Monsieur Gerd GOLL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 parts sociales
Monsieur Albert JACOBY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 parts sociales
Monsieur Fabio TRAPANI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 parts sociales

Monsieur Benoît VAN LERBERGHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 parts sociales

Monsieur Maik BEHRENDT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 parts sociales

Madame Kathrin STROBEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 parts sociales

Mr Emile GLODT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 parts sociales

Mr Madame Françoise CORBIAU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 parts sociales

Madame Josiane MATHIEU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 parts sociales

Madame Erna REHLES (vve. TRANCHIDA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 parts sociales

Madame Jacqueline TRAMARIN (épouse GOVAERTS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 parts sociales

Madame Marlie van der Tas Menten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 parts sociales

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 parts sociales

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014130694/40.
(140148159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2014.

Invensys European Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 341.705.296,66.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 65.165.

In the year two thousand and fourteen, on the eighteenth of July,
Before us, Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, Grandduchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

“BTR INDUSTRIES LIMITED”, a private limited liability company organized under the laws of England, with registered

office at 3 

rd

 Floor, 40 Grosvenor Place, London SW1X 7AW, registered with the Companies House of United Kingdom

under number 00478575,

here duly represented by Ms Coralie PAUWELS, lawyer, residing professionally at 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320

Luxembourg by virtue of a proxy given under private seal on July 7 

th

 , 2014.

The said proxy, after having been signed “ne varietur” by the proxy-holder representing the appearing person and the

notary will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing party, represented as aforesaid, is the sole member (the “Sole Member”) of “INVENSYS EUROPEAN

HOLDINGS S.À R.L.”, a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the
Grandduchy of Luxembourg, having its registered office at 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, registered with
the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 65165, incorporated by a deed received by Maître
Gérard LECUIT, notary then residing in Hesperange, on 24 June 1998, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés
et Associations number 675 on 22 September 1998 as amended several times and most recently by a deed received by
Maître Jean SECKLER, on 13 January 2010, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations number
1192 on 3 June 2011(the “Company”).

The Sole Member, represented as aforesaid, has requested the undersigned notary to act these resolutions contained

into the following agenda:

<i>Agenda:

1. Decision to change the accounting reference dates of the Company so that the current financial year which started

on the first day of April 2014 and should have end on the thirty first day of March 2015 is to be ended on the thirty first
day of December 2014 and that the following financial years of the Company shall begin on the first day of January of
each year and end on the thirty first day of December of the following year;

2. Subsequent decision to amend article 18 of the articles of association of the Company (the “Articles”) to reflect the

above resolution, as follows:

"The accounting year of the Company shall begin on the first day of January of each year and shall terminate on the

thirty first day of December of the following year.”

135214

L

U X E M B O U R G

3. Miscellaneous.

<i>First resolution

The Sole Member resolved to change the accounting reference dates of the Company so that the current financial

year which started on the first day of April 2014 and should have end on the thirty first day of March 2015 is to be ended
on the thirty first day of December 2014 and that the following financial years of the Company shall begin on the first
day of January of each year and end on the thirty first day of December of the following year.

<i>Second resolution

The Sole Member subsequently resolved to amend article 18 of the Articles of association to reflect the above reso-

lution, so that such article shall be read henceforth as follows:

"The accounting year of the Company shall begin on the first day of January of each year and shall terminate on the

thirty first day of December of the following year".

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever borne by the Company, as a result of the present deed,

are evaluated at approximately nine hundred and four euro (EUR 904,-).

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above

appearing parties, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
parties, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxy holder of the appearing party, he signed together with Us, the notary,

the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le dix-huitième jour du mois de juillet,
Par-devant nous, Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

A COMPARU:

«BTR INDUSTRIES LIMITED», une société de droit anglais dont le siège social est situé au 3 

rd

 Floor 40 Grosvenor

Place, London SW1X 7AW, immatriculée auprès du registre du Royaume-Uni sous le numéro 00478575,

ici représenté par Maître Coralie PAUWELS, Avocat à la Cour, demeurant professionnellement au 69, boulevard de

la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé en date du 7 Juillet 2014.

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par la mandataire de la partie comparante et par le notaire

instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La comparante, représentée comme ci-avant, est l'associée unique («l'Associé Unique») de «INVENSYS EUROPEAN

HOLDINGS S.À R.L.”, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois dont le siège social est situé au 8-10,
avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Société de Luxembourg sous le
numéro B 65165, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard LECUIT, notaire résidant alors à Hesperange, en date
du 24 juin 1998, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 675 du 22 septembre 1998 et dont
les statuts ont été modifiés a plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER en
date du 13 janvier 2010, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1192 du 3 juin 2011 (ci-après
la «Société»).

L’Associée Unique, représentée comme ci-avant, a requis le notaire instrumentant les résolutions contenues dans

l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Décision de changer les dates de référence comptables de la Société si bien que l'exercice social en cours qui a

commencé le premier avril 2014 et qui aurait du se terminer le trente-et-un mars 2015 se terminera en fait au trente-
et-un  décembre  2014  et  que  les  exercices  sociaux  suivants  commenceront  le  premier  janvier  de  chaque  année  et
prendront fin le trente-et-un décembre de l'année suivante;

2. Décision subséquente de modifier l'article 18 des statuts de la Société (les «Statuts») aux fins de refléter la résolution

précédente, comme suit:

«L’exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de l'année

suivante.»

3. Divers.

135215

L

U X E M B O U R G

<i>Première résolution

L’Associé Unique a décidé de changer les dates de référence comptables de la Société si bien que l'exercice social en

cours qui a commencé le premier avril 2014 et qui aurait du se terminer le trente-et-un mars 2015 se termine en fait au
trente-et-un décembre 2014 et que les exercices sociaux suivants commenceront le premier janvier de chaque année et
prendront fin le trente-et-un décembre de l'année suivante.

<i>Seconde résolution

L’Associé Unique a subséquemment décidé de modifier l'article 18 des Statuts de la Société, qui aura désormais la

teneur suivante:

«L’exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente-et-un décembre de l'année

suivante.»

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunération et charges incombant à la Société suite à cet acte sont estimés approximativement

à neuf cent quatre euros (904,- EUR).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg à la date en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu’à la requête de la partie comparante, représentée

comme indiqué ci-dessus, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française. A la demande de la
même partie, en cas de divergence entre les deux versions, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au représentant de la partie comparante, celui-ci a signé, avec Nous, le

notaire, le présent acte.

Signé: C. PAUWELS, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 juillet 2014. LAC/2014/34805. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 11 août 2014.

Référence de publication: 2014130704/112.
(140148093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2014.

Rhombus Ten S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 167.272.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014127394/9.
(140144291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2014.

Simak Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1318 Luxembourg, 58, rue des Celtes.

R.C.S. Luxembourg B 147.958.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014127422/9.
(140144333) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2014.

Sobel Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 86.511.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Windhof, le 08/08/2014.

Référence de publication: 2014127430/10.
(140144135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2014.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

135216


Document Outline

Aerlux

ALG Luxco S.à r.l.

Alistair Investissement S.A.

Altor CIB Holding S.à r.l.

Beim Engelchen S.à r.l.

Bull &amp; Bear Finance S.à r.l.

CCI Participations SA

Chazur Property S.A.

ContourGlobal Africa Holdings S.à r.l.

Demessy Investment S.A.

Essonne S.A.

Filmod International S.A.

FINIMPEX S.A., société de gestion de patrimoine familial

Galor Holding S.A. SPF

Ganges Holdings S.à r.l.

Heitman UCITS

Helvetia Capital Holding S.A.

Highstreet Propco II s.à R.L.

Ideal Standard International S.A.

Immobilière Saint Marcel S.A.

Immoparko S.A.

Interactive Creatures Environment Limited S.à r.l.

Invensys European Holdings S.à r.l.

Laboratoires Pharmedical S.A.

Loquacious S.A.

Manulife Global Fund

Olin Fund

Optimal Diversified Portfolio

PHV. s.à r.l.

Pioneer Investments Guaranteed Funds

Presence Communication

President B

Promox S.A. - SPF

Pro-Vision BRD S.à r.l.

Pro-Vision S.A.

Renson &amp; Associates Sàrl

Renson &amp; Associates Sàrl

Rhombus Ten S.à r.l.

Rive Private Investment

SAB, G.m.b.H.

Simak Sàrl

Sixth Dimension S.A.

Sobel Luxembourg S.à r.l.

Société Générale Private Wealth Management S.A.

Sources &amp; Trades Technology Services S.à r.l.

SPL S.A.

Suisimmo

Sustainable Assets No. 2

Thebes Capital Holding S.à r.l.

The Turquoise II Fund

Thunder Holding S.A., SPF

Titlis S.A., SPF

TRIWO Technopark Aachen Development S.à r.l.

Twin Holding 1 S.à.r.l

Valauchanrus Sopaneer S.C.A.

Valauchan Sopaneer International S.C.A.

VC Holding II S.à.r.l.