This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2787
8 octobre 2014
SOMMAIRE
Accharius Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133749
Acquatica S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133771
AEW Value Investors Asia II Feeder, L.P.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133771
AGR Europe S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133771
Airtime Projects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133768
Akira S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133771
Alfa 2011 S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133774
ALTAIRA Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133731
Ave Este Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . .
133775
Baek-Immo Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133776
Basic Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133730
Borrow Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
133770
BR Gaming Development S.A. . . . . . . . . . .
133776
BR Gaming Development S.A. . . . . . . . . . .
133776
b-to-v Private Equity S.C.S., SICAR . . . . . .
133767
Cana S.C.I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133757
eBay International AG (Luxembourg
branch) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133768
Garmin Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
133730
Hakon S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133749
Hayfin Capital LuxCo 2 . . . . . . . . . . . . . . . . .
133734
HBM BioCapital II Invest . . . . . . . . . . . . . . .
133769
Hefeng Holding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133733
HIB, Holding Invest Batiment S.A. . . . . . . .
133733
Hôtel Europe S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133731
Hotel Group Maas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133770
ICI Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133770
Icomi Investissement S.A. SPF . . . . . . . . . .
133772
IKAV General Partner S.à r.l. . . . . . . . . . . .
133772
Immo Pasha S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133774
Initiative S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133774
INM Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
133776
international quiding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
133768
Interportfolio II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133732
I-Real S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133769
Jewel HoldCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133742
JP Advice S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133769
Koch Chemical Technology LP1 S.à r.l. . .
133770
Les Servantes du Seigneur et de la Vierge
de Matará asbl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133775
LuxPol Invest S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133730
Mandatum Life Fund Management S.A. . .
133758
Mandatum Life Sicav-Sif . . . . . . . . . . . . . . . .
133750
Mikassa S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133734
NB Global Floating Rate Income Fund
(Lux) 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133731
New Luxis S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133772
Ojai Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133730
PepsiCo Investments Luxembourg S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133772
Roma Investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133736
S+B Inbau S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133732
SHCO 83 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133773
Smitham Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
133773
SONAFI Spf S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133775
Starpoint Holdings (Lux) BRL S.à r.l. . . . .
133773
Steyn Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133774
Ticketmaster Luxembourg Holdco 2, S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133734
Utah JV S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133731
VR Netze Luxemburg S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
133769
WD Luxis S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133772
133729
L
U X E M B O U R G
Garmin Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 153.686.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2014124245/10.
(140137682) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
août 2014.
LuxPol Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 50.000,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 136.957.
La dénomination de l'associé NFI EMPIK MEDIA & FASHION S.A. a changé et est désormais EMPIK MEDIA & FAS-
HION S.A.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juillet 2014.
Référence de publication: 2014124463/12.
(140138655) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
août 2014.
Basic Holding S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 46.465.
The shareholders are hereby convened to attend the
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
which is going to be held at the registered office on <i>27 October 2014i> at 10.00 a.m., with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. 1. Presentation and approval of the liquidator's report.
2. 2. Appointment of an auditor to liquidation.
This meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the capital represented.
<i>The Liquidatori>
Référence de publication: 2014154152/534/14.
Ojai Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 7A, rue des Glacis.
R.C.S. Luxembourg B 117.038.
Messieurs, Mesdames, les actionnaires, nous avons l'honneur de vous informer que vous êtes convoqués, le 24 octobre
2014, à 10.00 heures, au siège social, en
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
tenue extraordinairement, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
- Lecture des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice
clos le 31 décembre 2013, approbation desdits comptes, décharge aux administrateurs et au Commissaire aux
Comptes,
- Affectation du résultat,
- Examen de la situation des mandats (Ratification de la cooptation administrateur),
- Questions diverses.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2014147880/18.
133730
L
U X E M B O U R G
Hôtel Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.
R.C.S. Luxembourg B 166.352.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014124331/9.
(140138440) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
août 2014.
NB Global Floating Rate Income Fund (Lux) 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 164.429.
<i>Décision de l'actionnaire unique du 7 août 2014i>
Election de Madame Anne-Sophie Davreux, née le 13 novembre 1989 à Arlon (Belgique) et domiciliée professionnel-
lement au 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg en tant que gérante de la Société
pour une durée indéterminée et en remplacement de Monsieur Bernard Bronckart, décédé.
BNP Paribas Securities Services, Succursale de Luxembourg
Référence de publication: 2014131439/13.
(140149066) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2014.
Utah JV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: SEK 148.852,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 141.982.
EXTRAIT
En date du 10 juillet 2014, M. Robert Konigsberg, ayant son adresse professionnelle au 1001, Pennsylvania Avenue
NW, Suite 220 South, Washington DC 20004-2505, Etats-Unis d'Amérique, a démissionné de son poste de gérant de la
Société avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 août 2014.
Référence de publication: 2014126040/14.
(140143160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2014.
ALTAIRA Funds, Fonds Commun de Placement.
Im Rahmen der am 10. September 2014 erfolgten Auflösung des Global Tactical Solution, Fonds Commun de Placement
Teilfonds wird folgendes mitgeteilt:
Die Liquidation ist abgeschlossen und der Teilfonds wurde von der offiziellen Liste für Organismen für gemeinsame
Anlagen gestrichen.
Alle Investoren wurden ausbezahlt, es wurden keine Gelder an die Caisse de Consignation gezahlt.
Luxemburg, im Oktober 2014
ENGLISH TRANSLATION- ENGLISCHE ÜBERSETZUNG
Regarding the dissolution of the Global Tactical Solution, Fonds Commun de Placement on 10 September 2014 the
following shall be announced:
The liquidation process is completed and the sub fund has been removed from the official list of undertakings for
collective investment.
All investors were paid out, no liquidation proceeds were deposited at the Caisse de Consignation.
Luxembourg, October 2014
Référence de publication: 2014154151/795/17.
133731
L
U X E M B O U R G
S+B Inbau S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6430 Echternach, 13, route de Diekirch.
R.C.S. Luxembourg B 135.341.
AUSZUG
Die drei alleinigen Geschäftsführer erklären hiermit dass ihre Adressen geändert haben:
Herr Dirk Eppers
Heinrich-Raskin-Str. 15
D-54296 Trier
Herr Daniel Hack
12, Weckerstrooss
L-6830 Berbourg
Herr Christian Wolff
In der Held 3
D-54655 Malbergweich
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
S+B INBAU S.à r.l.
Unterschriften
Référence de publication: 2014131519/21.
(140148715) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2014.
Interportfolio II, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 49.512.
L'an deux mille quatorze, le trente-et-un juillet.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg,
s'est tenue
une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme sous la forme d’une société d’inves-
tissement à capital variable INTERPORTFOLIO II (la "Société") ayant son siège social à L-2085 Luxembourg, 23, avenue
de la Porte-Neuve, constituée suivant acte notarié en date du 14 décembre 1994, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations (le «Mémorial»), numéro 34, page 1588 de 1995.
L'assemblée est présidée par Madame Gwendoline Boone, employée de banque, demeurant professionnellement à
Hesperange.
Le président a désigné comme secrétaire Madame Aline Biej, employée de banque, demeurant professionnellement à
Hesperange.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Sylvie Dobson employée de banque, demeurant professionnellement
à Hesperange.
Le bureau ainsi constitué, le président a déclaré et prié le notaire d'acter:
I. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Décision de liquider la Société;
2. Nomination du liquidateur et détermination de ses pouvoirs;
3. Approbation du paiement des créanciers et distribution des actifs restant aux actionnaires, après paiement des
dettes;
4. Décision de suspendre le calcul de la valeur nette d’inventaire, les rachats, les souscriptions et les conversions.
II. Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre des actions détenues par chacun d’eux sont renseignés
sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et par le
bureau de l’assemblée ainsi que par le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise
avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés après avoir été para-
phées "ne varietur" par les comparants.
III. Qu'il résulte de la liste de présence que sur les 39.517 actions en circulation, 39.517 actions sont représentées à
la présente Assemblée générale extraordinaire, de sorte que celle-ci peut délibérer valablement sur son ordre du jour,
133732
L
U X E M B O U R G
les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connais-
sance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ces faits ayant été approuvés par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
En conformité avec les articles 141 à 151 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée,
(la “Loi de 1915”), l’assemblée décide de dissoudre la Société et de commencer la procédure de liquidation avec effet
immédiat.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution ci-dessus, l’assemblée décide de nommer en tant que liquidateur la société Alter
Domus Liquidation Services S.à r.l., avec siège social à 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, RCS Luxembourg B
142389, représentée par Madame Delphine André et Monsieur Frank-Matthias Przygodda.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis de la Loi de 1915.
Il peut en particulier accomplir tous les actes prévus par l’article 145 de la Loi de 1915 sans devoir recourir à l’auto-
risation de l’assemblée générale dans les cas où elle est requise.
Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droit réels, privi-
lèges, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées ou
hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.
Le liquidateur est dispensé de l’inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires
telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée approuve le paiement aux créanciers de toutes les dettes de la Société et la distribution des actifs restants
aux actionnaires.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de suspendre le calcul de la valeur nette d’inventaire, les rachats, les souscriptions et les conver-
sions.
DONT ACTE, fait et passé à Hesperange, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux personnes comparantes, celles-ci ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: G. BOONE, A. BIEJ, S. DOBSON et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 4 août 2014. Relation: LAC/2014/36862. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 12 août 2014.
Référence de publication: 2014129514/69.
(140146377) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2014.
Hefeng Holding, Société Anonyme.
Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.
R.C.S. Luxembourg B 161.800.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014124326/9.
(140137753) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
août 2014.
HIB, Holding Invest Batiment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9753 Heinerscheid, 62, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 162.095.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014124330/9.
(140138641) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
août 2014.
133733
L
U X E M B O U R G
Hayfin Capital LuxCo 2, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R.C.S. Luxembourg B 145.040.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 juillet 2014.
Référence de publication: 2014124305/10.
(140137984) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
août 2014.
Mikassa S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 183.019.
Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de rési-
dence à Esch/Alzette, en date du 11 avril 2014 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 12 mai 2014.
Référence de publication: 2014125781/11.
(140143040) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2014.
Ticketmaster Luxembourg Holdco 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 139.790.
In the year two thousand and fourteen, on the twelfth of August.
Before Us, Maître Henri BECK, notary residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
There appeared:
Ms. Peggy SIMON, private employee, with professional address at 9, Rabatt, L-6475 Echternach, Grand Duchy of
Luxembourg,
acting in her capacity as a special proxy holder of the board of managers of “Ticketmaster Luxembourg Holdco 2, S.à
r.l.”, a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg, having its registered office at 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 139.790 (the “Absorbing Company”),
pursuant to resolutions made by the board of managers of the Absorbing Company on August 11, 2014, and pursuant
to a power of attorney given on August 11, 2014.
A copy of these board resolutions as well as the said power of attorney, after having been signed “ne varietur” by the
proxyholder and the notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.
The Absorbing Company has been incorporated by notarial deed of Maître Henri Beck, notary residing in Echternach,
Grand Duchy of Luxembourg, dated June 25
th
, 2008, published in the “Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations”,
number 1780, on July 18, 2008.
This appearing party, through its proxyholder, has declared and requested the notary to state that:
1. - The Absorbing Company holds one hundred percent (100%) of the shares of Ticketmaster Luxembourg Holdco
3, S.à r.l., a private limited liability company (“société à responsabilité limitée”) incorporated under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg, having its registered office at 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand Duchy of Lu-
xembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 139.828 (the “Absorbed
Company”).
2. - The board of managers of the Absorbing Company as well as the board of managers of the Absorbed Company
(together the “Merging Companies”) have adopted the common draft merger terms which were executed in front of the
undersigned notary on June 11, 2014, and which were published, pursuant to article 262 of the law of August 10
th
, 1915
on commercial companies as amended from time to time (the “Law”), in the “Mémorial C - Recueil des Sociétés et
Associations”, number 1615, on June 24, 2014 (the “Merger Terms”).
3. - The documents provided for by article 267 paragraph 1 a), b), and c) of the Law (i.e., the Merger Terms and the
annual accounts and annual reports of the Merging Companies for the last three financial years), were put at the disposal
133734
L
U X E M B O U R G
of the sole shareholder of the Merging Companies at their registered office one month prior to the date of the approval
of the merger.
4. - The board of managers decided to approve and to acknowledge the effects of the merger as set out in article 274
(1) a), c) and d) of the Law, without any restriction or limitation, of the Absorbed Company, into the Absorbing Company,
as stated in the Merger Terms.
5. - No objections to the merger were received between the date of publication of the Merger Terms and the date
of the meetings of the board of managers of the Absorbed Company and the Absorbing Company.
6. - The merger takes effect as of August 11, 2014, with accounting effect starting on January 1
st
, 2014.
7. - Full and complete discharge is granted to the members of the Board of managers of the Absorbed Company for
the proper performance of their duties until today.
8. - The accounting books and documents of the Absorbed Company will be kept during a period of five (5) years at
least at the registered office of the Absorbing Company.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above
appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
party, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof, the present deed was drawn up in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg, at the date indicated at the
beginning of the document.
After reading the present deed to the proxy-holder, acting as said before, known to the notary by her name, first
name, civil status and residence, the said proxy-holder signed together with Us, the notary, the present deed.
Suit la version en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille quatorze, le douze août.
Par-devant Nous, Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
A comparu:
Madame Peggy SIMON, employée privée, avec adresse professionnelle au 9 Rabatt, L-6475 Echternach, Grand-Duché
de Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spéciale du conseil de gérance de «Ticketmaster Luxembourg Holdco 2, S.à r.l.»,
une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au
560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 139.790 (la «Société Absorbante»),
en vertu d'un pouvoir lui ayant été conféré sur base des résolutions prises par le conseil de gérance de la Société
Absorbante en date du 11 août 2014 et conformément à une procuration délivrée le août 2014.
Une copie de ces résolutions du conseil de gérance ainsi que la procuration précitée, après avoir été signées «ne
varietur» par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte afin d'être enregistrées avec
lui.
La Société Absorbante a été constituée par acte notarié de Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach,
Grand-Duché de Luxembourg, en date du 25 juin 2008, publié au Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 1780, le 18 juillet 2008.
Laquelle comparante, par son mandataire, a déclaré et requis le notaire instrumentaire d'acter que:
1. - La Société Absorbante détient cent pourcent (100%) des parts sociales de «Ticketmaster Luxembourg Holdco 3,
S.à r.l.», une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège
social au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 139.828 (la «Société Absorbée»).
2. - Le conseil de gérance de la Société Absorbante ainsi que le conseil de gérance de la Société Absorbée (ensemble
les «Sociétés Fusionnantes») ont adopté un projet commun de fusion qui a été exécuté par devant le notaire soussigné
le 11 juin 2014 et qui a été publié, conformément aux dispositions de l'article 262 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales telle que modifiée (la «Loi»), au Mémorial C -Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1615, le 24 juin
2014 (le «Projet de Fusion»).
3. - Les documents requis par l'article 267 paragraphe 1 a), b), et c) de la Loi (c.-à-d. le Projet de Fusion et les comptes
annuels et les rapports de gestion des trois derniers exercices sociaux des Sociétés Fusionnantes), ont été tenus à dis-
position des associés des Sociétés Fusionnantes à leur siège social durant un mois précédant la date d'approbation de la
fusion.
4. - Le conseil de gérance a décidé d'approuver et de reconnaître les effets de la fusion tels que stipulés dans l'article
274 (1) a), c) et d) de la Loi, sans restriction ni limitation, de la Société Absorbée à la Société Absorbante, comme indiqué
dans les Projet de Fusion.
133735
L
U X E M B O U R G
5. - Aucune objection à l'encontre de la fusion n'a été communiquée entre la date de publication du Projet de Fusion
et la date des réunions des conseils de gérance de la Société Absorbée et de la Société Absorbante.
6. - La fusion prend effet à la date du 11 août 2014, avec effet comptable au 1
er
janvier 2014.
7. - Décharge pleine et entière est accordée aux membres des conseils de gérance de la Société Absorbée pour
l'exercice de leurs mandats jusqu'à aujourd'hui.
8. - Les documents et pièces comptables relatifs à la Société Absorbée resteront conservés pendant une période de
cinq (5) ans au moins au siège social de la Société Absorbante.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et le français, déclare par les présentes, qu'à la requête de la partie
comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même partie comparante,
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.
Dont acte, le présent acte a été passé à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, à la date indiquée en tête des
présentes.
Après lecture du présent acte au mandataire, agissant comme dit ci-avant, connue du notaire par son nom, prénom,
état civil et domicile, ladite mandataire a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: P. SIMON, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 12 août 2014. Relation: ECH/2014/1526. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri>
(signé): J.-M. MINY.
Pour expédition conforme, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
Echternach, le 18 août 2014.
Référence de publication: 2014130936/111.
(140148351) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2014.
Roma Investments, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2347 Luxembourg, 1, rue du Potager.
R.C.S. Luxembourg B 172.333.
The year two thousand and fourteen, on the twenty-fourth day of July.
Before Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held
an extraordinary general meeting of shareholders of "Roma Investments S.A.", a company incorporated under Lu-
xembourg law, having its registered office at L-2347 Luxembourg, 1, rue du Potager, Grand Duchy of Luxembourg,
registered with the register of Commerce and Companies of Luxembourg under number B 172333 (hereinafter the
"Company"), incorporated on the 12
th
of October 2012 by deed of the undersigned notary, published in the Mémorial
Recueil des Sociétés et Associations number 2990 of 10 December 2012 and whose articles of incorporation have not
been amended.
The meeting was chaired by Mrs Solange Wolter-Schieres, residing professionally in Luxembourg.
The president appointed as secretary and the meeting elected as scrutineer Ms Sandrine Dubois, residing professionally
in Luxembourg.
The President has requested the undersigned to state that:
The chairman requests the notary to act that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance
list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered
with the minutes.
II.As appears from the attendance list all the four hundred and eighty thousand (480,000) shares representing the whole
capital of the corporation, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which
the shareholders have been beforehand informed.
III.- The agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. Changing the legal form of the Company, without changing the corporate purpose, to adopt one of a limited liability
company, and change the name to "Roma Investments."
2. Allocation of shares.
3. Evaluation of the social net assets and determining the amount of capital.
133736
L
U X E M B O U R G
4. Resignation of the auditor.
5. Resignation of the sole director, discharge and appointment of the manager of the Company.
6. Adoption of new statutes.
The statement of the President, after verification by the scrutineer is acknowledged as correct by the assembly and it
is considered validly constituted, composed of a sole shareholder and able to deliberate on the items on the agenda
shareholder.
Following the approval of the foregoing by the sole shareholder, the following resolutions were adopted:
The sole shareholder requires the notary to record the following:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder decides to change the legal form of the Company, without changing the corporate purpose, to
adopt one of a limited liability company, and change the name to "Roma Investments."
<i>Allocation of sharesi>
The 480,000 (four hundred eighty thousand) existing fully paid shares continue to exist and remain in circulation but
are converted into shares and exchanged against 480,000 (four hundred eighty thousand) shares with a nominal value of
EUR 1 (one euro) each, fully paid, representing the entire share capital and all attributed to the sole shareholder Mr Marc
Michiels, born in Braine l’Alleud, Belgium, on 22 April 1977, residing in Los Trapenses 4949 casa 5 Lo Barnecchea (Chile).
<i>Evaluationi>
Based on financial position of the Company and stopped at 31 December 2013, based on a statement by the sole
director of the Company, annexed, net assets of the Company is at least EUR 480,000, - (four hundred eighty thousand
euros).
Therefore, the meeting decided to fix the issued and fully paid capital of the Company at EUR 480,000, - (four hundred
eighty thousand euros), represented by 480,000 (four hundred eighty thousand) shares with a nominal value of EUR 1.-
(euro) each, all belonging to the sole shareholder prequalified.
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder acknowledges and accepts the resignation of the auditor of the Company with effect from the
date of that day and decided to give it a discharge for the implementation of its mandate, the latter ending on the date
hereof resolutions.
<i>Third resolutioni>
The sole shareholder gives discharge to the sole director for the execution of his mandate as of this date and confirms
his appointment, from that day for an indefinite period, this time as manager of the Company.
<i>Fourth resolutioni>
The sole shareholder decides to adopt new Articles of the Company, to give them as follows
Chapter I. - Name - Registered office - Duration - Corporate purpose - Capital Form and name
Art. 1. These articles govern a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) named
«Roma Investments» (here-after the “Company”).
Registered office
Art. 2. The registered office is established in Luxembourg-City.
The Company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand-Duchy of Luxem-
bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the Board.
Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office
of the Company has been determined by contract with third parties, the registered office may be transferred to any other
place within the municipality of the registered office or abroad, by a decision of the members. The Company shall remain
a Luxembourg company.
Duration
Art. 3. The Company is established for an unlimited period.
Corporate purpose
Art. 3. The Company's purpose is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial,
industrial, financial or other, Luxembourg or foreign companies or enterprises and to acquire through participations,
contributions, underwriting, purchases or options, negotiation or in any other way any securities, rights, patents and
licences, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage,
develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and in
133737
L
U X E M B O U R G
particular for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in financial,
commercial and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other
company which belong to the same group of companies than the Company any assistance, loans, advances or guarantees;
to borrow and raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed.
The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all
areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.
Capital
Art. 5. The Company's issued share capital is set at EUR 480,000 (four hundred eighty thousand euros), represented
by 480,000) (four hundred eighty thousand) corporate units with a nominal value of EUR 1 (one euro) each.
Art. 6. The capital may be increased or reduced at any time as laid down in the law.
Art. 7. Each corporate unit entitles its owner to a proportional right in the Company's assets and profits.
Art. 8. The Company has initially one member. The Company may have several members at any time following a
division, a transfer of corporate units or the creation of new corporate units. In this case, corporate units are freely
transferable among members. The transfer of corporate unit inter vivos to non-members is subject to the consent of the
members representing at least seventy-five percent of the Company's capital.
In case of death of a member, the transfer of corporate unit to non-members is subject to the consent of no less than
three quarters of the votes belonging to the surviving members. In any event the remaining members have a preemption
right which has to be exercised within 30 (thirty) days from the refusal of transfer to a non-member.
Art. 9. The Company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy, insolvency, dissolution or winding-up of
one of the members.
Art. 10. For no reason and in no case, the heirs, creditors or other rightful claimants of the members are allowed to
pursue the sealing of property or documents of the Company.
Chapter II. - Board of management - General meeting Board of management
Art. 11. The Company will be managed by one or more managers who need not to be members and who are appointed
by the sole member or the general meeting of members in case of plurality of members.
Provided they conform to the rules here-after, managers, have without reservation towards third parties the widest
powers in order to take any decisions binding the Company and to act for and on behalf on it in any circumstances.
Art. 12. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible. As agents of the Company,
they are responsible for the correct performance of their duties.
For no reason and in no case, the heirs, creditors or other rightful claimants of the managers are allowed to pursue
the sealing of property or documents of the Company.
Towards third parties, the Company is in all circumstances committed by the single signature of the sole manager, or
by the joint signatures of two managers or by the sole signature of a delegate of the management acting within the limits
of his powers. In its current relations with the public administration, the Company is validly represented by any manager.
General meeting
Art. 13. Every member may take part in the collective decisions in the general meetings of members. He has a number
of votes equal to the number of corporate units he owns and may validly act at the meetings through a special proxy.
Art. 14. Collective decisions are only valid if they are adopted by the members representing more than half of the
capital.
However, decisions concerning the amendment of the articles of incorporation are taken by a majority of the members
representing three quarters of the capital.
A sole member exercises alone all the powers devolved to the general meeting.
Chapter III. - Business year - Allocation of profits Business year
Art. 15. The business year begins on January 1
st
and ends on December 31 of each year.
Art. 16. Every year on December 31, the annual accounts are drawn up by the managers.
Art. 17. The financial statements are at the disposal of the members at the registered office of the Company.
Allocation of profits
Art. 18. At least 5% of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund. Such contri-
bution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches 10% of the subscribed capital.
The remaining balance is at the disposal of the members.
133738
L
U X E M B O U R G
Chapter IV. - Dissolution - Liquidation
Art. 19. The Company may be dissolved by a decision of the sole member or the general meeting voting with the same
quorum as for the amendment of the articles of incorporation.
Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need not to
be members and who are appointed by the general meeting which will specify their powers and remuneration.
Art. 20. For anything not dealt with in the present articles of incorporation, the members refer to the law of August,
10 1915 relating to commercial companies.
<i>Costi>
Costs, fees, taxes or charges in any form whatsoever, to be borne by the Company or to be paid by it in connection
with this transformation were estimated EUR 2,500.-
Nothing being on the agenda, the meeting was adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,
Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present
original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille quatorze, le vingt-quatre juillet.
Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est tenue
l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de «Roma Investments S.A.», une société anonyme de droit
luxembourgeois, ayant son siège social à L-2347 Luxembourg, 1, rue du Potager, Grand-Duché de Luxembourg, imma-
triculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 172333 (ci-après la «Société»),
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, le 12 octobre 2012, publié au Mémorial Recueil des Sociétés
et Associations C numéro 2990 du 10 décembre 2012 et dont les statuts n’ont pas été modifiés.
L'assemblée est présidée par Madame Solange Wolter-Schieres, demeurant professionnellement à Luxembourg.
La présidente nomme comme secrétaire et l’assemblée élit comme scrutateur Madame Sandrine Dubois, demeurant
professionnellement à Luxembourg.
La présidente a requis le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.
II.- Il appert de la liste de présence que toutes les quatre cent quatre-vingt mille (480.000,-) actions, représentant
l’intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée
peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.
III.- L'ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Changement de la forme juridique de la Société, sans en modifier l’objet social, pour adopter celle d’une société à
responsabilité limitée, et modification de la dénomination sociale en «Roma Investments».
2. Allocation des parts sociales.
3. Évaluation de l’actif net social et fixation du montant du capital.
4. démission du commissaire aux comptes.
5. Démission de l’administrateur unique, décharge et nomination du gérant de la Société.
6. Adoption de nouveaux statuts.
L'exposé du Président, après vérification par le scrutateur, est reconnu exact par l’assemblée et celle-ci se considère
comme valablement constituée, composée d’un actionnaire unique et apte à délibérer sur les points à l’ordre du jour.
Suite à l’approbation de ce qui précède par l’actionnaire unique, les résolutions suivantes ont été adoptées:
L’actionnaire unique requiert le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
<i>Première résolutioni>
L’actionnaire unique décide de changer la forme juridique de la Société, sans en modifier l’objet social, pour adopter
celle d’une société à responsabilité limitée, et de modifier la dénomination sociale en «Roma Investments».
133739
L
U X E M B O U R G
<i>Allocation des parts socialesi>
Les 480.000 (quatre cent quatre-vingt mille) actions intégralement libérées existantes continuent à exister et restent
en circulation mais sont converties en parts sociales et échangées contre 480.000 (quatre cent quatre-vingt mille) parts
sociales d'une valeur nominale d'1 EUR (un euro) chacune, entièrement libérées, représentant l’intégralité du capital social
et toutes attribuées à l’associé unique Monsieur Marc Michiels, né à Braine l’Alleud, Belgique, le 22 avril 1977, demeurant
à Los Trapenses 4949 casa 5 Lo Barnecchea (Chili).
<i>Évaluationi>
Sur base d’une situation financière de la Société arrêtée au 31 décembre 2013, et sur base d’une déclaration de
l’administrateur unique de la Société, ci-annexée, l’actif net de la Société est au moins égal à EUR 480.000,- (quatre cent
quatre-vingt mille euros).
Par conséquent, l’assemblée décide de fixer le capital émis et entièrement libéré de la Société à EUR 480.000,- (quatre
cent quatre vingt mille euros), représenté par 480.000 (quatre cent quatre vingt mille) parts sociales d'une valeur nominale
d'1 EUR (un euro) chacune, appartenant toutes à l’associé unique préqualifié.
<i>Seconde résolutioni>
L’associé unique prend acte de et accepte la démission du commissaire aux comptes de la Société avec effet à la date
de ce jour et décide de lui donner décharge pour l’exécution de son mandat, celui-ci prenant fin à la date des présentes
résolutions.
<i>Troisième résolutioni>
L’associé unique donne décharge à l’administrateur unique pour l’exécution de son mandat jusqu'à ce jour et confirme
sa nomination, dès ce jour et pour une durée indéterminée, cette fois en tant que gérant de la Société.
<i>Quatrième résolutioni>
L’associé unique décide d’adopter de nouveaux statuts de la Société, pour leur donner la teneur suivante:
Titre I
er
. - Forme - Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital Forme et dénomination.
Art. 1
er
. Ces statuts régissent une société à responsabilité limitée luxembourgeoise dénommée «Roma
Investments» (ci-après la “Société”).
Siège social.
Art. 2. Le siège de la Société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision de la gérance, la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs
aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l’étranger.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la Société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la Société pourra être transféré sur décision de l’associé unique ou des associés
à tout autre endroit du Luxembourg ou, moyennant unanimité, à l’étranger.
Durée
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Objet social
Art. 4. L'objet de la Société est de prendre des participations et intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans toutes
sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, d'acquérir
par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre
manière tous titres, droits, valeurs, brevets et licences et autres droits réels, droits personnels et intérêts, comme la
Société le jugera utile, et de manière générale de les détenir, les gérer, les mettre en valeur et les céder en tout ou en
partie, pour le prix que la Société jurera adapté et en particulier pour les actions ou titres de toute société les acquérant;
de conclure, d'assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou autres et d'octroyer à toute
société holding, filiale ou toute autre société liée d'une manière ou d'une autre à la Société ou toute société participant
au même groupe de sociétés, tout concours, prêts, avances ou garanties; d'emprunter ou de lever des fonds de quelque
manière que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée.
La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte
avec les secteurs pré décrits et aux fins de faciliter l’accomplissement de son objet.
Capital social
Art. 5. Le capital social est fixé à 480.000 EUR (quatre cent quatre vingt mille euros), représenté par 480.000 (quatre
cent quatre vingt mille) parts sociales d'une valeur nominale d'1 EUR (un euro) chacune.
Art. 6. Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi.
133740
L
U X E M B O U R G
Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle de l’actif social et des bénéfices.
Art. 8. La Société comporte initialement un associé unique. Elle peut à tout moment comporter plusieurs associés par
suite notamment de cession ou de transmission totale ou partielle des parts sociales ou de création de parts nouvelles.
Dans ce cas, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés que moyennant l’agrément donné par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément des
propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants. En toute hypothèse,
les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer dans un délai franc de trente (30) jours calculé à
partir de la date du refus de cession à un non-associé.
Art. 9. Le décès, l’interdiction, l’incapacité, la faillite, la déconfiture ou la dissolution de l’un des associés ne mettent
pas fin à la Société.
Art. 10. Les héritiers, créanciers ou, autres ayants droit ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire, apposer
des scellés sur les biens et documents de la Société.
Titre II. - Gérance - Assemblée Générale Gérance
Art. 11. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’associé unique ou
l’assemblée générale des associés en cas de pluralité d'associés.
Pourvu qu'ils se conforment aux règles ci-après, les gérants ont sans réserves vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus
étendus pour prendre toutes décisions engageant la Société et pour agir au nom de celle-ci dans toutes les circonstances.
Art. 12. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle. Simples mandataires, ils
ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat.
Les héritiers, créanciers ou autres ayants droit des gérants ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer
des scellés sur les biens et documents de la Société.
Vis-à-vis des tiers, la Société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant unique ou par
les signatures conjointes d'au moins deux gérants ou, pour des opérations déterminées, par la signature d'un délégué de
la gérance dans les limites de ses pouvoirs. La signature de chaque gérant sera toutefois suffisante pour représenter
valablement la Société dans ses rapports avec les administrations publiques.
Assemblée générale
Art. 13. Chaque associé peut participer aux décisions collectives lors de l’assemblée générale des associés. Il a un
nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées
par un porteur de procuration spéciale.
Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des
associés représentant les trois quarts du capital social.
Un associé unique exerce seul toutes les prérogatives dévolues à l’assemblée générale.
Titre III. - Année sociale - Répartition des bénéfices
Année sociale
Art. 15. L'année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 16. Chaque année, le 31 décembre, le conseil de gérance établit les comptes annuels.
Art. 17. Tout associé peut prendre communication des comptes annuels de la Société au siège social.
Répartition des bénéfices
Art. 18. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.
Le solde est à la disposition des associés.
Titre IV. - Dissolution - Liquidation
Art. 19. La Société peut être dissoute par décision de l’associé unique ou de l’assemblée générale le cas échéant,
statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, associés
ou non, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.
Art. 20. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent à la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales et à ses modifications ultérieures, qui trouveront leur application partout où il n'y
a pas été valablement dérogé par les présents statuts.
133741
L
U X E M B O U R G
<i>Estimation des coûtsi>
Les coûts, frais, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être
payés par elle en rapport avec cette transformation, ont été estimés à EUR 2.500,-
Plus rien n'étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
A la demande des comparants le notaire, qui parle et comprend l’anglais, a établi le présent acte en anglais suivi d'une
version française. Sur demande des comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le
texte anglais fait foi.
Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les
membres du bureau ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: S. WOLTER, S. DUBOIS et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 31 juillet 2014. Relation: LAC/2014/36374. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri>
(signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 22 septembre 2014.
Référence de publication: 2014149101/305.
(140169722) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2014.
Jewel HoldCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 64.844.031,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 173.021.
In the year two thousand and fourteen, on the twenty-fifth day of August.
Before us Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
1) AIF VII Euro Holdings, L.P., a Cayman Islands exempted limited partnership, having its registered office at c/o Walkers
SPV Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002, Cayman Islands, duly represented
by its general partner Apollo Advisors VII (EH), L.P., represented by its general partner Apollo Advisors VII (EH-GP), Ltd.
here represented by Ms Alina Rymalova, Rechtsanwältin, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under
private seal,
2) AP Jewel Holdings (EH-1), LLC, a Delaware limited liability company, having its registered office at Corporation
Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, with registration number 5301133,
here represented by Ms Alina Rymalova, Rechtsanwältin, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under
private seal,
3) AP Jewel Holdings (EH-2), LLC, a Delaware limited liability company, having its registered office at Corporation
Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, with registration number 5301136,
here represented by Ms Alina Rymalova, Rechtsanwältin, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under
private seal,
4) AP Jewel Holdings (EH-3), LLC, a Delaware limited liability company, having its registered office at Corporation
Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, with registration number 5301138,
here represented by Ms Alina Rymalova, Rechtsanwältin, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under
private seal,
5) AP Jewel Holdings (EH-4), LLC, a Delaware limited liability company, having its registered office at Corporation
Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, with registration number 5301140,
here represented by Ms Alina Rymalova, Rechtsanwältin, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under
private seal,
6) AP Jewel Holdings (EH-5), LLC, a Delaware limited liability company, having its registered office at Corporation
Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, with registration number 5301143,
here represented by Ms Alina Rymalova, Rechtsanwältin, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under
private seal,
7) AP Jewel Holdings (EH-6), LLC, a Delaware limited liability company, having its registered office at Corporation
Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, with registration number 5301146,
here represented by Ms Alina Rymalova, Rechtsanwältin, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under
private seal,
133742
L
U X E M B O U R G
8) AP Jewel Holdings (EH-7), LLC, a Delaware limited liability company, having its registered office at Corporation
Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, with registration number 5301150,
here represented by Ms Alina Rymalova, Rechtsanwältin, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under
private seal,
9) AP Jewel Holdings (EH-8), LLC, a Delaware limited liability company, having its registered office at Corporation
Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, with registration number 5301155,
here represented by Ms Alina Rymalova, Rechtsanwältin, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under
private seal,
10) AP Jewel Holdings (EH-9), LLC, a Delaware limited liability company, having its registered office at Corporation
Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, with registration number 5301159,
here represented by Ms Alina Rymalova, Rechtsanwältin, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under
private seal,
11) AP Jewel Holdings (EH-10), LLC, a Delaware limited liability company, having its registered office at Corporation
Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, with registration number 5369804,
here represented by Ms Alina Rymalova, Rechtsanwältin, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under
private seal,
12) Mr. Justin Stead, residing at Halo House, 27 Windsor Road, Gerrards Cross, Bucks, SL9 7ND, England,
here represented by Ms Alina Rymalova, Rechtsanwältin, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under
private seal,
13) Mr. Thomas J. O’Neill, residing at 6 Stonehurst Common, NH 03755 Hanover, USA,
here represented by Ms Alina Rymalova, Rechtsanwältin, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under
private seal,
14) Mr. Anthony Broderick, residing at 5 Bridgnorth Road, Stourton, Stourbridge, DY7 6RP, England,
here represented by Ms Alina Rymalova, Rechtsanwältin, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under
private seal,
15) Miss Ruth Benford, residing at 50 Marigold Lane, Mountsorrel, Loughborough, LE12 7FP, England,
here represented by Ms Alina Rymalova, Rechtsanwältin, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under
private seal,
16) Mr. Craig Bolton, residing at 4 Sandmill Mews, Winlaton, Tyne & Wear, NE21 5SF, England,
here represented by Ms Alina Rymalova, Rechtsanwältin, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under
private seal,
17) Mr. James Crichton, residing at 67 Northampton Road, Towcester, Northants, NN12 7AH, England,
here represented by Ms Alina Rymalova, Rechtsanwältin, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under
private seal,
18) Kesef Investments LLC, a limited liability company incorporated in the State of North Carolina, having its registered
office at 3605 Glenwood Avenue, Ste. 500, Raleigh, Wake County, North Carolina 27612.
here represented by Ms Alina Rymalova, Rechtsanwältin, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under
private seal,
19) Mr. Hugh Brian Duffy, residing at 13 Denbigh Gardens, Richmond, London, TW10 6EN, England
here represented by Ms Alina Rymalova, Rechtsanwältin, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under
private seal,
20) Mr. François Le Troquer, residing at 14 Cygnet House, 188 Kings Road, London SW3 5XR, England
here represented by Ms Alina Rymalova, Rechtsanwältin, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under
private seal,
21) Ms. Lucy Maitland Walker, residing at 3 Weir Road, Kibworth Be, England,
here represented by Ms Alina Rymalova, Rechtsanwältin, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under
private seal,
The said proxies, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary, will remain annexed
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing parties are all the shareholders of Jewel Holdco S.à r.l. (hereinafter the “Company”), a société à
responsabilité limitée, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Lu-
xembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 173 021, incorporated
pursuant to a notarial deed of the notary Henri Hellinckx, prenamed, on 22 November 2012, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, number 8 dated 2 January 2013. The articles of association have last been amended
through a deed of the notary Henri Hellinckx, prenamed, on 11 August 2014, not yet published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations.
133743
L
U X E M B O U R G
The appearing parties, representing the whole corporate capital, requested the undersigned notary to act that the
agenda is as follows:
<i>Agendai>
1) Decision to increase the Company’s share capital from its current amount of five hundred forty-five thousand eight
hundred twenty-nine Pounds Sterling and eighty-five pence (GBP 545,829.85) represented by one million forty thousand
and four (1,040,004) A Ordinary Shares, four thousand six hundred eighty-nine (4,689) A1 Ordinary Shares, fifty-three
million three hundred fifty-five thousand nine hundred sixty (53,355,960) Preference Shares, forty-four thousand two
hundred eight (44,208) B Ordinary Shares and one hundred thirty-eight thousand one hundred twenty-four (138,124) C
Ordinary Shares having a nominal value of one Pence (GBP 0.01) each, up to six hundred forty-eight thousand four hundred
forty Pounds Sterling and thirty-one pence (GBP 648,440.31) through the issue of one hundred ninety-nine thousand
forty-seven (199,047) A Ordinary Shares, eight hundred ninety-six (896) A1 Ordinary Shares, five thousand two hundred
seventy-nine (5,279) B Ordinary Shares and ten million fifty-five thousand eight hundred twenty-four (10,055,824) Pre-
ference Shares, having a nominal value of one Pence (GBP 0.01) each, to be paid by a contribution in cash.
2) Amendment of article 5 of the articles of incorporation of the Company.
3) Decision to appoint an independent auditor (réviseur d’entreprises agréé) of the Company.
4) Miscellaneous.
The appearing parties, represented as stated above, representing the entire share capital, take the following resolutions:
<i>First Resolutioni>
The extraordinary general meeting of the shareholders decides to increase the Company’s share capital from its current
amount of five hundred forty-five thousand eight hundred twenty-nine Pounds Sterling and eighty-five pence (GBP
545,829.85) represented by one million forty thousand and four (1,040,004) A Ordinary Shares, four thousand six hundred
eighty-nine (4,689) A1 Ordinary Shares, fifty three million three hundred fifty-five thousand nine hundred sixty
(53,355,960) Preference Shares, forty-four thousand two hundred eight (44,208) B Ordinary Shares and one hundred
thirty-eight thousand one hundred twenty-four (138,124) C Ordinary Shares having a nominal value of one Pence (GBP
0.01) each, up to six hundred forty-eight thousand four hundred forty Pounds Sterling and thirty-one pence (GBP
648,440.31) through the issue of one hundred ninety-nine thousand forty-seven (199,047) A Ordinary Shares, eight
hundred ninety-six (896) A1 Ordinary Shares, five thousand two hundred seventy-nine (5,279) B Ordinary Shares and
ten million fifty-five thousand eight hundred twenty-four (10,055,824) Preference Shares, having a nominal value of one
Pence (GBP 0.01) each, to be paid by a contribution in cash.
The newly issued shares are subscribed and fully paid up as follows:
1) one hundred ninety-nine thousand forty-seven (199,047) A Ordinary Shares and nine million seven hundred fifty-
three thousand two hundred ninety-three (9,753,293) Preference Shares are subscribed and fully paid up by AIF VII Euro
Holdings, L.P., prenamed, here represented as aforementioned, for a price of seven million nine hundred sixty-one thou-
sand eight hundred seventy two Pounds Sterling and seventy-five pence (GBP 7,961,872.75),
2) eight hundred ninety-six (896) A1 Ordinary Shares and forty-three thousand nine hundred thirty-eight (43,938)
Preference Shares are subscribed and fully paid up by Kesef Investments LLC, prenamed, here represented as aforemen-
tioned, for a price of thirty-five thousand eight hundred sixty-seven Pounds Sterling and twenty-four pence (GBP
35,867.24),
3) four hundred seventy-eight (478) B Ordinary Shares and twenty-three thousand four hundred twenty-nine (23,429)
Preference Shares are subscribed and fully paid up by Mr Thomas J. O’Neill, prenamed, here represented as aforemen-
tioned, for a price of nineteen thousand one hundred twenty-four Pounds Sterling and eighty-three pence (GBP 19,124.83),
4) three thousand two hundred seventy-eight (3,278) B Ordinary Shares and one hundred sixty thousand six hundred
eleven (160,611) Preference Shares are subscribed and fully paid up by Duffy Management and Investments Ltd,, having
its registered office at 13 Denbigh Gardens, Richmond, London TW10 6EN, England, here represented by Ms Alina
Rymalova, Rechtsanwältin, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal, for a price of one hundred
thirty-one thousand one hundred eleven Pounds Sterling (GBP 131,111),
5) one thousand one hundred fifty-one (1,151) B Ordinary Shares and fifty-six thousand three hundred ninety-four
(56,394) Preference Shares are subscribed and fully paid up by Mr Anthony Broderick, prenamed, here represented as
aforementioned, for a price of forty-six thousand thirty-five Pounds Sterling (GBP 46,035),
6) fifty (50) B Ordinary Shares and two thousand four hundred thirty-four (2,434) Preference Shares are subscribed
and fully paid up by Mr François Le Troquer, prenamed, here represented as aforementioned, for a price of one thousand
nine hundred eighty-seven Pounds Sterling and thirty-two pence (GBP 1,987.32),
7) fifty (50) B Ordinary Shares and two thousand four hundred thirty-four (2,434) Preference Shares are subscribed
and fully paid up by Ms Lucy Maitland Walker, prenamed, here represented as aforementioned, for a price of one thousand
nine hundred eighty-seven Pounds Sterling and thirty-two pence (GBP 1,987.32),
8) one hundred fifty-two (152) B Ordinary Shares and seven thousand four hundred twenty-six (7,426) Preference
Shares are subscribed and fully paid up by Ms Ruth Benford, prenamed, here represented as aforementioned, for a price
of six thousand sixty-one Pounds Sterling and ninety-two pence (GBP 6,061.92),
133744
L
U X E M B O U R G
9) one hundred twenty (120) B Ordinary Shares and five thousand eight hundred sixty-five (5,865) Preference Shares
are subscribed and fully paid up by Mr James Crichton, prenamed, here represented as aforementioned, for a price of
four thousand seven hundred eighty-eight Pounds Sterling and two pence (GBP 4,788.02),
The shares so subscribed have been fully paid-up by a contribution in cash so that the amount of eight million two
hundred eight thousand eight hundred thirty-five Pounds Sterling and forty pence (GBP 8,208,835.40) is as of now available
to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
Of the total subscription price of eight million two hundred eight thousand eight hundred thirty-five Pounds Sterling
and forty pence (GBP 8,208,835.40), one hundred two thousand six hundred ten Pounds Sterling and forty-six pence
(GBP 102,610.46) shall be allocated to the share capital of the Company, and eight million one hundred six thousand two
hundred twenty-four Pounds Sterling and ninety-four pence (GBP 8,106,224.94) shall be allocated to the share premium
account.
As a consequence, Duffy Management and Investments Ltd, prenamed, here represented by Ms Alina Rymalova,
Rechtsanwältin, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal, joins the extraordinary general
meeting of the shareholders of the Company and votes on the following resolutions.
The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
<i>Second Resolutioni>
As a consequence of the above resolution, the extraordinary general meeting of the shareholders decides to amend
article 5 of the articles of incorporation of the Company to read as follows:
“ Art. 5. Capital.
5.1. The Company's share capital is set at six hundred forty-eight thousand four hundred forty Pounds Sterling and
thirty-one pence (GBP 648,440.31) represented by one million two hundred thirty-nine thousand fifty-one (1,239,051)
A Ordinary Shares, five thousand five hundred eighty-five (5,585) A1 Ordinary Shares, sixtythree million four hundred
eleven thousand seven hundred eighty-four (63,411,784) Preference Shares, forty-nine thousand four hundred eighty-
seven (49,487) B Ordinary Shares and one hundred thirty-eight thousand one hundred twenty-four (138,124) C Ordinary
Shares having a nominal value of one Pence (GBP 0.01) each, all subscribed and fully paid-up.
5.2. The share capital may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the sole shareholder or
of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.”
<i>Third Resolutioni>
The extraordinary general meeting of the shareholders decides to appoint KPMG Luxembourg S.à r.l., a société à
responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register under number B 149133, having its registered office at 9, allée Scheffer,
L-2520 Luxembourg, as independent auditor (réviseur d'entreprises agréé) for the audit of the consolidated accounts of
the Company with immediate effect, appointed for a period ending on the date of the approval of the consolidated
accounts for the financial year 2014 by the annual general meeting of the shareholders.
<i>Costs and Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it
by reason of the present deed are assessed to EUR 5,000.-.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-
ment.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,
the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing parties and
in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, known to the notary by name, first name,
civil status and residence, the said proxyholder of the person appearing signed together with the notary the present deed.
Follows the French translation of the preceding deed
L’an deux mille quatorze, le vingt-cinq août.
Par-devant nous, Maître Henri Hellinckx, notaire, de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
ONT COMPARU:
1) AIF VII Euro Holdings, L.P., un exempted limited partnership existant selon les lois des Îles Caïmans, ayant son siège
social à c/o Walkers SPV Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002, Îles Caïmans,
représenté par son commandité Apollo Advisors VII (EH), L.P., représenté par son commandité Apollo Advisors VII (EH-
GP), Ltd.,
représenté par Madame Alina Rymalova, Rechtsanwältin, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée
sous seing privé,
133745
L
U X E M B O U R G
2) AP Jewel Holdings (EH-1), LLC, une limited liability company existant selon les lois de l’Etat du Delaware, ayant son
siège social à Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, sous le
numéro 5301133,
représentée par Madame Alina Rymalova, Rechtsanwältin, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée
sous seing privé,
3) AP Jewel Holdings (EH-2), LLC, une limited liability company existant selon les lois de l’Etat du Delaware, ayant son
siège social à Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, sous le
numéro 5301136,
représentée par Madame Alina Rymalova, Rechtsanwältin, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée
sous seing privé,
4) AP Jewel Holdings (EH-3), LLC, une limited liability company existant selon les lois de l’Etat du Delaware, ayant son
siège social à Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, sous le
numéro 5301138,
représentée par Madame Alina Rymalova, Rechtsanwältin, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée
sous seing privé,
5) AP Jewel Holdings (EH-4), LLC, une limited liability company existant selon les lois de l’Etat du Delaware, ayant son
siège social à Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, sous le
numéro 5301140,
représentée par Madame Alina Rymalova, Rechtsanwältin, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée
sous seing privé,
6) AP Jewel Holdings (EH-5), LLC, une limited liability company existant selon les lois de l’Etat du Delaware, ayant son
siège social à Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, sous le
numéro 5301143,
représentée par Madame Alina Rymalova, Rechtsanwältin, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée
sous seing privé,
7) AP Jewel Holdings (EH-6), LLC, une limited liability company existant selon les lois de l’Etat du Delaware, ayant son
siège social à Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, sous le
numéro 5301146,
représentée par Madame Alina Rymalova, Rechtsanwältin, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée
sous seing privé,
8) AP Jewel Holdings (EH-7), LLC, une limited liability company existant selon les lois de l’Etat du Delaware, ayant son
siège social à Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, sous le
numéro 5301150,
représentée par Madame Alina Rymalova, Rechtsanwältin, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée
sous seing privé,
9) AP Jewel Holdings (EH-8), LLC, une limited liability company existant selon les lois de l’Etat du Delaware, ayant son
siège social à Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, sous le
numéro 5301155,
représentée par Madame Alina Rymalova, Rechtsanwältin, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée
sous seing privé,
10) AP Jewel Holdings (EH-9), LLC, une limited liability company existant selon les lois de l’Etat du Delaware, ayant
son siège social à Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, sous
le numéro 5301159,
représentée par Madame Alina Rymalova, Rechtsanwältin, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée
sous seing privé,
11) AP Jewel Holdings (EH-10), LLC, une limited liability company existant selon les lois de l’Etat du Delaware, ayant
son siège social à Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, sous
le numéro 5369804,
représentée par Madame Alina Rymalova, Rechtsanwältin, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée
sous seing privé,
12) Monsieur Justin Stead, résidant au Halo House, 27 Windsor Road, Gerrards Cross, Bucks, SL9 7ND, England,
représenté par Madame Alina Rymalova, Rechtsanwältin, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée
sous seing privé.
13) Monsieur Thomas J. O’Neill, résidant au 6 Stonehurst Common, Hanover, NH 03755, Etats-Unis,
représenté par Madame Alina Rymalova, Rechtsanwältin, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée
sous seing privé.
14) Monsieur Anthony Broderick, résidant au 5 Bridgnorth Road, Stourton, Stourbridge, DY7 6RP, Angleterre,
133746
L
U X E M B O U R G
représenté par Madame Alina Rymalova, Rechtsanwältin, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée
sous seing privé,
15) Madame Ruth Benford, résidant au 50 Marigold Lane, Mountsorrel, Loughborough, LE12 7FP, Angleterre,
représentée par Madame Alina Rymalova, Rechtsanwältin, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée
sous seing privé,
16) Monsieur Craig Bolton, résidant au 4 Sandmill Mews, Winlaton, Tyne & Wear, NE21 5SF, Angleterre,
représenté par Madame Alina Rymalova, Rechtsanwältin, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée
sous seing privé,
17) Monsieur James Crichton, résidant au 67 Northampton Road, Towcester, Northants, NN12 7AH, Angleterre,
représenté par Madame Alina Rymalova, Rechtsanwältin, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée
sous seing privé,
18) Kesef Investments LLC, une société à responsabilité limitée existant sous les lois de l’Etat de la Caroline du Nord,
ayant son siège social à 3605 Glenwood Avenue, Ste. 500, Raleigh, Wake County, Caroline du Nord 27612,
représentée par Madame Alina Rymalova, Rechtsanwältin, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée
sous seing privé,
19) Monsieur Hugh Brian Duffy, résidant au 13 Denbigh Gardens, Richmond, London, TW10 6EN, England
représenté par Madame Alina Rymalova, Rechtsanwältin, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée
sous seing privé,
20) Monsieur François Le Troquer, résidant au 14 Cygnet House, 188 Kings Road, London SW3 5XR, England
représenté par Madame Alina Rymalova, Rechtsanwältin, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée
sous seing privé,
21) Madame Lucy Maitland Walker, résidant au 3 Weir Road, Kibworth Be, England,
représentée par Madame Alina Rymalova, Rechtsanwältin, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée
sous seing privé,
Les procurations, paraphées ne varietur par le mandataire des comparants et par le notaire, resteront annexées au
présent acte pour être soumises avec lui aux formalités d’enregistrement.
Les comparants sont tous les associés de Jewel Holdco S.à r.l. (ci-après la “Société”), une société à responsabilité
limitée, ayant son siège social 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 173 021, constituée selon acte reçu
par le notaire Henri Hellinckx, prénommé, en date du 22 novembre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 8 en date du 2 janvier 2013. Les statuts ont été modifiés la dernière fois suivant acte reçu par le
notaire Henri Hellinckx, prénommé, en date du 11 août 2014, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations.
Lesdites comparantes, représentant l’intégralité du capital social, demandent au notaire soussigné de constater que
l’ordre du jour est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Décision d’augmenter le capital social de la Société de son montant actuel de cinq cent quarante-cinq mille huit cent
vingt-neuf livres sterling et quatre-vingt-cinq pence (GBP 545.829,85) représenté par un million quarante mille quatre
(1.040.004) Actions Ordinaires A, quatre mille six cent quatre-vingt-neuf (4.689) Actions Ordinaires A1, cinquante-trois
millions trois cent cinquante-cinq mille neuf cent soixante (53.355.960) Actions de Préférence, quarante-quatre mille deux
cent huit (44.208) Actions Ordinaires B et cent trente-huit mille cent vingt-quatre (138.124) Actions Ordinaires C, d’une
valeur nominale de un pence (GBP 0,01) chacune, à un montant de six cent quarante-huit mille quatre cent quarante livres
sterling et trente et un pence (GBP 648.440,31), par l’émission de cent quatre-vingt-dix-neuf mille quarante-sept (199.047)
Actions Ordinaires A, huit cent quatre-vingt-seize (896) Actions Ordinaires A1, cinq mille deux cent soixante-dix-neuf
(5.279) Actions Ordinaires B et dix million cinquante-cinq mille huit cent vingt-quatre (10.055.824) Actions de Préférence,
d’une valeur nominale de un pence (GBP 0,01) chacune, par une contribution en numéraire.
2. Modification de l’article 5 des statuts de la Société.
3. Décision de nommer un réviseur d’entreprises agréé de la Société.
4. Divers.
Les comparants, précités ci-dessus, représentant l’intégralité du capital social, prennent les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des associés décide d’augmenter le capital social de la Société de son montant
actuel de cinq cent quarante-cinq mille huit cent vingt-neuf livres sterling et quatre-vingt-cinq pence (GBP 545.829,85)
représenté par un million quarante mille quatre (1.040.004) Actions Ordinaires A, quatre mille six cent quatre-vingt-neuf
(4.689) Actions Ordinaires A1, cinquante-trois millions trois cent cinquante-cinq mille neuf cent soixante (53.355.960)
Actions de Préférence, quarante-quatre mille deux cent huit (44.208) Actions Ordinaires B et cent trente-huit mille cent
133747
L
U X E M B O U R G
vingt-quatre (138.124) Actions Ordinaires C, d’une valeur nominale de un pence (GBP 0,01) chacune, à un montant de
six cent quarante-huit mille quatre cent quarante livres sterling et trente-et-un pence (GBP 648.440,31), par l’émission
de cent quatre-vingt-dix-neuf mille quarante-sept (199.047) Actions Ordinaires A, huit cent quatre-vingt-seize (896) Ac-
tions Ordinaires A1, cinq mille deux cent soixante-dix-neuf (5.279) Actions Ordinaires B et dix million cinquante-cinq
mille huit cent vingt-quatre (10.055.824) Actions de Préférence, d’une valeur nominale de un pence (GBP 0,01) chacune,
par une contribution en numéraire.
Les nouvelles parts sociales ont été souscrites et entièrement libérées comme suit:
1) cent quatre-vingt-dix-neuf mille quarante-sept (199.047) Actions Ordinaires A et neuf millions sept cent cinquante-
trois mille deux cent quatre-vingt-treize (9.753.293) Actions de Préférence sont intégralement souscrites et libérées par
AIF VII Euro Holdings, L.P., susmentionnée, représentée comme il est dit, pour un prix total de sept millions neuf cent
soixante et un mille huit cent soixante-douze livres sterling et soixante-quinze pence (GBP 7.961.872,75),
2) huit cent quatre-vingt-seize (896) Actions Ordinaires A1 et quarante-trois mille neuf cent trente-huit (43.938)
Actions de Préférence sont intégralement souscrites et libérées par Kesef Investments LLC, susmentionnée, représentée
comme il est dit, pour un prix total de trente-cinq mille huit cent soixante-sept livres sterling et vingt-quatre pence (GBP
35.867,24),
3) quatre cent soixante-dix-huit (478) Actions Ordinaires B et vingt-trois mille quatre cent vingt-neuf (23.429) Actions
de Préférence sont intégralement souscrites et libérées par Monsieur Thomas J. O’Neill, susmentionné, représenté com-
me il est dit, pour un prix total de dix-neuf mille cent vingt-quatre livres sterling et quatre-vingt-trois pence (GBP
19.124,83),
4) trois mille deux cent soixante-dix-huit (3.278) Actions Ordinaires B et cent soixante mille six cent onze (160.611)
Actions de Préférence sont intégralement souscrites et libérées par Duffy Management and Investments Ltd, ayant son
siège social au 13 Denbigh Gardens, Richmond, London TW10 6EN, Angleterre, ici représentée par Madame Alina Ry-
malova, Rechtsanwältin, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé, pour un prix total
de cent trente et un mille cent onze livres sterling (GBP 131.111),
5) mille cent cinquante et un (1.151) Actions Ordinaires B et cinquante-six mille trois cent quatre-vingt-quatorze
(56.394) Actions de Préférence sont intégralement souscrites et libérées par Monsieur Anthony Broderick, susmentionné,
représenté comme il est dit, pour un prix total de quarante-six mille trente-cinq livres sterling (GBP 46.035),
6) cinquante (50) Actions Ordinaires B et deux mille quatre cent trente-quatre (2.434) Actions de Préférence sont
intégralement souscrites et libérées par Monsieur François Le Troquer, susmentionné, représenté comme il est dit pour
un prix total de mille neuf cent quatre-vingt-sept livres sterling et trente-deux pence (GBP 1.987,32),
7) cinquante (50) Actions Ordinaires B et deux mille quatre cent trente-quatre (2.434) Actions de Préférence sont
intégralement souscrites et libérées par Madame Lucy Maitland Walker, susmentionnée, représentée comme il est dit,
pour un prix total de mille neuf cent quatre-vingt-sept livres sterling et trente-deux pence (GBP 1.987,32),
8) cent cinquante-deux (152) Actions Ordinaires B et sept mille quatre cent vingt-six (7.426) Actions de Préférence
sont intégralement souscrites et libérées par Madame Ruth Benford, susmentionnée, représentée comme il est dit, pour
un prix total de six mille soixante et un livres sterling et quatre-vingt-douze pence (GBP 6.061,92),
9) cent vingt (120) Actions Ordinaires B et cinq mille huit cent soixante-cinq (5.865) Actions de Préférence sont
intégralement souscrites et libérées par Monsieur James Crichton, susmentionné, représenté comme il est dit, pour un
prix total de quatre mille sept cent quatre-vingt-huit livres sterling et deux pence (GBP 4.788,02),
Les actions souscrites, ont été entièrement libérées par un apport en numéraire, de sorte que la somme de huit millions
deux cent huit mille huit cent trente-cinq livres sterling et quarante pence (GBP 8.208.835,40) est dès maintenant à la
disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.
De l’apport global d’un montant de huit millions deux cent huit mille huit cent trente-cinq livres sterling et quarante
pence (GBP 8.208.835,40), cent deux mille six cent dix livres sterling et quarante-six pence (GBP 102.610,46) sont alloués
au capital social de la Société et huit millions cent six mille deux cent vingt-quatre livres sterling et quatre-vingt-quatorze
pence (GBP 8.106.224,94) sont alloués à la prime d’émission.
Par la suite, Duffy Management and Investments Ltd, précitée, ici représentés par Madame Alina Rymalova, Rechtsan-
wältin, résidant à Luxembourg, en vertu de la procuration donnée sous seing privé, se joint à l’assemblée générale des
associés de la Société et décide des points suivants à l’ordre du jour.
La procuration, paraphée ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire, restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités d’enregistrement.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, l’assemblée générale extraordinaire des associés décide de modifier
l’article 5 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:
« Art. 5. Capital.
5.1 Le capital social de la Société est fixé à six cent quarante-huit mille quatre cent quarante livres sterling et trente
et un pence (GBP 648.440,31) représenté par un million deux cent trente-neuf mille cinquante et un (1.239.051) Actions
Ordinaires A, cinq mille cinq cent quatre-vingt-cinq (5.585) Actions Ordinaires A1, soixante-trois millions quatre cent
133748
L
U X E M B O U R G
onze mille sept cent quatre-vingt-quatre (63.411.784) Actions de Préférence, quarante-neuf mille quatre cent quatre-
vingt-sept (49.487) Actions Ordinaires B et cent trente-huit mille cent vingt-quatre (138.124) Actions Ordinaires C, d’une
valeur nominale de un pence (GBP 0,01) chacune, intégralement souscrites et libérées.
5.2 Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit par une décision de l’assemblée générale des associés prise
dans les conditions requises pour une modification des présents Statuts.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des associés décide de nommer KPMG Luxembourg S.à r.l., une société à res-
ponsabilité limitée, constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 149133, ayant son siège social au 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg,
comme réviseur d'entreprises agréé pour le contrôle légal des comptes consolidés de la Société avec effet immédiat
jusqu'à la date d’approbation des comptes consolidés de la Société pour l’exercice social 2014 par l’assemblée générale
annuelle des associés.
<i>Frais et Dépensesi>
Le montant des frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature qui incombe à la Société en raison de cet acte
est évalué à environ EUR 5.000,-.
Dont acte, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu'à la demande des comparants, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français; et qu'à la demande des mêmes comparants et en cas de
divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
L'acte ayant été lu au mandataire des comparants connu du notaire instrumentant par nom, prénom, et résidence,
ledit mandataire des comparants a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. RYMALOVA et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 septembre 2014. Relation: LAC/2014/41023. Reçu soixante-quinze euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): C. FRISING.
- POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 17 septembre 2014.
Référence de publication: 2014146798/407.
(140166864) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2014.
Hakon S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 37.838.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014124317/10.
(140138083) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
août 2014.
Accharius Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1320 Luxembourg, 54, rue de Cessange.
R.C.S. Luxembourg B 36.017.
Constituée le 22 janvier 1991 pardevant Me André Schwachtgen en remplacement de Me Franck Baden matricule 1991
40 00 486
Le bilan au 31 décembre 2013, le compte de profits et pertes pour la période du 1
er
janvier 2013 au 31décembre
2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Accharius Invest S.A.
Signature
Référence de publication: 2014124503/15.
(140141881) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2014.
133749
L
U X E M B O U R G
Mandatum Life Sicav-Sif, Société à responsabilité limitée sous la forme d'une SICAF - Fonds d'Investis-
sement Spécialisé.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 190.480.
STATUTES
In the year two thousand and fourteen, on the second day of September.
Before Maître Francis Kesseler, notary residing at Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
THERE APPEARED:
Mandatum Life Insurance Company Limited, a company incorporated in Finland, having its registered office at Bulevardi
56, FI-00120 Helsinki, Finland, and under the supervision of the Finnish Financial Supervisory Authority,
here represented by Mrs Sophie Henryon, an employee having with professional address at 5, rue Zénon Bernard,
L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;
Hereinafter referred to as the “Party”.
The above mentioned proxy, being initialed ne varietur by the appearing party, and the undersigned notary, shall remain
attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party has, in the capacity of which it acts, requested the notary to draw up the following articles of
Association (the Articles of Association) of a public limited company (“société anonyme”) (the “Company”), the incor-
poration of which such party has approved.
Art. 1. Form. There is hereby formed among the subscriber(s) and all persons who may become holder of shares
hereafter issued, a company in the form of a public limited company (“société anonyme”), formed as an investment
company with variable capital (“SICAV”)” and Specialized Investment Fund, governed by the present Articles of Asso-
ciation and by current Luxembourg laws, and notably by the Law on Commercial Companies of 10 August 1915 (the
“1915 Law”) and the law on Specialized Investment Funds of 13 February 2007 (the “2007 Law”) and qualifying as alter-
native investment fund (“AIF”) in the meaning of and in accordance with Directive 2011/61/EU on alternative investment
fund managers as amended from time to time and implemented into Luxembourg law by the law of 12 July 2013 on
alternative investment fund managers (the “Law of 2013”).
The Company is managed by Mandatum Life Management Company S.A., a public limited company incorporated under
the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and which acts as the appointed external alternative investment fund manager
of the Company in the meaning of the Law of 2013.
Art. 2. Name. The Company's name is MANDATUM LIFE SICAV-SIF.
Art. 3. Purpose. The Company's exclusive object is the collective investment of its funds in assets in order to spread
the investment risks and to ensure for the investors the benefit of the results of the management of these assets according
to its investment objectives and policies in accordance with the provisions of the 2007 Law and applicable Luxembourg
Supervisory Authority's (the “CSSF”) circulars.
The investment objectives and strategy of the Company are more fully described in the Company's offering document.
The Company may also enter into, assist or participate in any financial, commercial and other transactions, and in
particular, without limitation, grant any assistance, loans, advances or guarantees and raise money in any manner and
secure the repayment of any money borrowed from third parties or from its shareholders.
In addition, the Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indi-
rectly to all areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose to the full extent permitted
by the 2007 Law.
Art. 4. Registered Office. The registered office of the Company is established in Luxembourg in the Grand Duchy of
Luxembourg. It may be transferred to any other place within the Grand-Duchy of Luxembourg by a resolution of the
general meeting of shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the same municipality by simple resolution of the board
of directors of the Company (the “Board of Directors”).
The Board of Directors shall further have the right to set up branches, offices, administrative centers and agencies
wherever it shall deem fit, either within or outside of the Grand Duchy of Luxembourg.
Where the Board of Directors determines that extraordinary political, economical or social developments or events
have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the
Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the regis-
tered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances.
Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a company incorporated in the Grand Duchy of Luxembourg.
133750
L
U X E M B O U R G
Art. 5. Duration. The Company is constituted for an unlimited duration.
The Company may be terminated at any time by a decision of the general meeting of shareholders in the manner
required for the amendment of these Articles of Association.
The life of the Company does not come to an end upon the death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency
of any of its shareholders or members of the Board of Directors.
Art. 6. Share Capital. The initial share capital of the Company is set at thirty one thousand Euros (EUR 31,000) divided
into three hundred ten (310) fully paid up Shares, with no par value. The Company's share capital shall at any time be
equal to its net asset value, as determined in accordance with Article twelve (12) hereafter.
The minimum subscribed capital of the Company, which must be achieved within 12 (twelve) months as from the date
on which the Company has been authorized as a Specialized Investment Fund by the CSSF, shall be one million two
hundred fifty thousand Euros (EUR 1,250,000.-) as required by the 2007 Law.
Art. 7. The sub-funds and classes of shares. The Company is a multi-compartment structure consisting of one or several
sub-funds, each one representing a specific portfolio of assets and liabilities. There is no cross liability between sub-funds.
Each sub-fund is invested in accordance with the investment objective and policy applicable to it. The investment objective
and policy as well as other specific features of each sub-fund will be set forth in the Company's offering document. The
Board of Directors may decide to create at any time additional sub-funds or to close an existing sub-fund.
The Board of Directors may decide to issue, within each sub-fund, separate classes of shares, which may carry different
rights and obligations, inter alia with regard to their distribution policy and right to revenues, their fee structure, their
minimum initial subscription and holding amounts or their target investors. The specific features of the classes within each
sub-fund will be set forth in the Company's offering document. The Board of Directors may create at any time additional
classes or close an existing class.
Art. 8. Form of shares / Register of shareholders. Shares will only be issued in registered form. All issued shares of
the Company shall be registered in the register of shareholders. Such register shall contain the name and address of each
shareholder, the number of shares held by it and, if applicable, their date of transfer.
The registration of the shareholder's name in the register of shares evidences its right of ownership over such regis-
tered shares. The shareholder shall receive a written confirmation of its shareholding. The shareholder may, at any time,
change its address as entered in the register of shareholders by means of a written notification to the Company at its
registered office, or at such other address as may be set by the Company from time to time.
Fractions of shares may be issued, up to four decimal places.
Art. 9. Shareholders. The holding of shares is exclusively restricted to «Well-Informed Investors» as defined in the
2007 Law.
The Board of Directors shall have the power to impose such restrictions as it may think necessary for the purpose
notably of ensuring that no shares in the Company are acquired or held by (a) any person in breach of these Articles of
Association, the offering document of the Company, the law or requirement of any country or governmental authority,
or (b) any person in circumstances which in the opinion of the Board of Directors might result in the Company incurring
any liability to taxation or suffering any other pecuniary disadvantage which the Company might not otherwise have
incurred or suffered. For such purposes the Board of Directors may:
a) decline to issue any share and decline to register any transfer of a share where it appears to it that such registration
or transfer would or might result in legal or beneficial ownership of such share being held by a person who is precluded
from holding shares of the Company;
b) at any time require any person whose name is entered in the register of shareholders to furnish it with any infor-
mation, supported by affidavit, which it may consider necessary for the purpose of determining whether or not legal or
beneficial ownership of such shareholder's shares rests or will rest in a person who is precluded from holding shares of
the Company; and
c) where it appears to the Company that any person, who is precluded from holding shares of the Company is a legal
or beneficial owner of shares or holds shares, cause the Company compulsorily to repurchase from any such shareholder
all shares held by such shareholder.
Art. 10. Issue of shares. Whenever shares of the Company shall be offered by the Company for subscription, the price
per share at which such shares shall be issued shall be the net asset value thereof as determined in accordance with the
provisions of Article 12 hereof on the basis of the fair value principle. The Board of Directors may also decide that an
issue commission has to be paid. The allotment of Shares is conditional upon payment and if timely payment has not been
received within the settlement period, the subscription may lapse and be cancelled at the cost of the investor or the
investor's financial intermediary. If payment is not received in full, the relevant allotment of Shares may be reduced
accordingly. The Board of Directors may in its discretion determine the minimum amount of any subscription in any Class
of share of any sub-fund.
Subscriptions received before a certain hour (“cut-off time”) on a specific date (which does not need to be the valuation
date) as determined by the Board of Directors from time to time shall be processed at the net asset value determined
133751
L
U X E M B O U R G
for the applicable valuation date. If subscriptions are received after that cut-off time as determined by the Board of
Directors from time to time, they shall be processed at the net asset value determined for the following valuation date.
The investor will bear any taxes or other expenses attaching to the application.
The Board of Directors may agree to issue shares as consideration for a contribution in kind of securities to any
shareholder who agrees to comply with any conditions set forth by the Board of Directors from time to time including,
but not limited to, the obligation to deliver a valuation report from the auditor of the Company which shall be available
for inspection, and provided that such securities comply with the investment restrictions and policies of the relevant sub-
fund, as set forth in the Company's offering document. Any costs incurred in connection with a contribution in kind of
securities, including the auditor's costs for preparing any valuation report required, shall be borne by the shareholder
making such contribution.
The Board of Directors reserves the right to accept or refuse any application of subscription for shares in whole or
in part.
Art. 11. Transfer and conversion of shares. Any transfer of shares to the existing shareholders or to any third party
shall require the prior written approval of the Board of Directors and the Board of Directors may in its discretion and
without indicating any reason decline to approve or register such transfer.
The Board shall not accept any transfer of shares to any transferee who may not be considered as an eligible investor
within the meaning of the Law.
The shareholder wishing to transfer its shares in the Company will be responsible for all costs associated with any
attempted or realized transfer.
Shareholders are not allowed to pledge or grant a security interest in any of their shares without the prior consent
of the Board of Directors.
Unless otherwise provided for within the Company's offering document, (i) shares of a sub-fund may not be converted
for shares in another sub-fund and (ii) shares of a sub-fund may be converted for shares in another class of shares of the
same sub-fund, subject to the prior written approval of the Board of Directors.
Art. 12. Net asset value. The net asset value of the Company shall be determined as often as the Board of Directors
may think useful, but in no event less than once a year.
The net asset value will be expressed in Euro and shall be determined by the central administrator on the basis of the
fair valuation of the underlying assets of the Company as provided by the Board of Directors on each valuation date by
aggregating the value of all assets of the Company and deducting all liabilities of the Company.
If needed, the net asset value may be calculated by using swing pricing methodology to ensure a fair treatment between
investors.
Art. 13. Suspension. The Board of Directors may temporarily suspend the calculation of the net asset value during:
a) any period when, in the reasonable opinion of the Board of Directors, a fair valuation of the assets of the Company
is not practicable for reasons beyond the control of the Company; or
b) any period when any of the principal markets on which a substantial proportion of the assets of the Company are
quoted are closed (otherwise than for ordinary holidays), or during which dealings thereon are restricted or suspended;
or
c) the existence of any state of affairs which constitutes an emergency as a result of which valuation of assets owned
by the Company would be impractical; or
d) any breakdown in, or restriction in the use of, the means of communication normally employed in determining the
price or value of any of the Investments or the currency price or values on any such stock exchange; or
e) when, following redemption requests, it has not proved possible to dispose of the assets of the concerned sub-fund
(s) as necessary as a consequence of the markets' liquidity.
Art. 14. Redemption of shares. The Company is an open-ended Specialized Investment Fund. However, the Board of
Directors may decide, depending on the investment strategy and objectives of each sub-fund, to launch closed-ended sub-
funds.
Redemptions will be made in accordance with the principles set forth in the offering document of the Company for
each sub-fund.
The payment of the redemption price shall be made for cash or consideration in kind at the discretion of the Board
of Directors. The allotment of Company's assets in respect of redemption for consideration in kind shall be fair and not
detrimental to the interests of the other shareholders of the Company. In compliance with the provisions of the 2007
and 1915 Laws, any redemption for consideration in kind shall be subject to the confirmation by an auditor's special report
of the valuation of the Company of the Company's assets to be allocated, the costs of which shall be borne by the
Company.
Redemption of shares shall be made at a price, which is determined by the Board of Directors to be the fair value for
the shares to be redeemed by applying the principles described in the Company's offering document. The rules relating
to distributions as set forth in the Company's offering document of the Company are furthermore applicable.
133752
L
U X E M B O U R G
The Company may decide to compulsorily redeem the shares wholly or in part in particular in the following circums-
tances:
a) the shares are held by shareholders not authorized to buy or own shares in the Company, i.e. a shareholder that
no longer qualifies as «Well-Informed Investor» as defined in the 2007 Law or such shareholder (or an affiliate of the
same) that becomes a U.S. person as referred to in the Company's offering document;
b) in the event that a shareholder is declared bankrupt, enters into an arrangement for the benefit of its creditors or
goes into liquidation;
c) in case of liquidation or merger of sub-funds or classes of shares;
d) in order to distribute the proceeds of realization of investments;
e) in all other circumstances as the Board of Directors may deem appropriate in accordance with the terms and
conditions set out in the Company's offering document.
Except in the cases c) and d) above the Board of Directors may impose such penalty as it deems fair and appropriate.
All redeemed shares or fractions thereof shall be automatically cancelled.
Art. 15. Board of Directors. The Company will be managed by the Board of Directors of the Company, composed of
not less than three (3) members, being exclusively derived from or selected by Mandatum Life Insurance Company Limited
and/ or Sampo Group. The members of the Board of Directors need not be shareholders of the Company.
The Directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting for a period not exceeding six (6)
years and shall hold office until their successor are elected. A Director may be removed with or without cause and
replaced at any time by resolution adopted by the shareholders.
In the event of vacancy in the office of a Director because of death, retirement or otherwise, the remaining Directors
may meet and elect, by majority of vote, a Director to fill such vacancy until the next meeting of the shareholders.
Art. 16. Chairman. The Board of Directors shall elect from among its members a Chairman and may choose from
among its members one or more Vice-Chairmen. It may also choose a secretary, who needs not to be a Director, who
shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors and of the shareholders. The Board
of Directors shall meet upon call by the Chairman, or two Directors, at the place indicated in the notice of meeting.
The Chairman shall preside at all meetings of shareholders or in his absence or inability to act, the Vice-Chairman or
another Director appointed by the Board of Directors shall preside as chairman pro-tempore, or in their absence or
inability to act, the shareholders may appoint another Director or an officer of the Company as chairman pro tempore
by vote of the majority of shares present or represented at any such meeting.
The Chairman shall preside at all meetings of the Board of Directors, or in his absence or inability to act, the Vice-
Chairman or another Director appointed by the Board of Directors shall preside as chairman pro-tempore.
The Board of Directors shall from time to time appoint any officer or agent of the Company considered necessary for
the operation and management of the Company, who need not be Directors or shareholders of the Company. The
officers appointed unless otherwise stipulated in these Articles, shall have the power and duties granted to them by the
Board of Directors.
Written notice of any meeting of the Board of Directors shall be given to all Directors at least twenty-four (24) hours
in advance of the hour set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances
shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by cable, telefax or any
other similar or electronic communication means from each Director. Separate notice shall not be required for meetings
held at times and places set out in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors.
Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing another Director as his proxy, which
appointment shall be in writing or in form of a facsimile or any other similar or electronic communication means.
Directors may also assist at board meetings and board meetings may be held by telephone link or telephone conference,
provided that the vote be confirmed in writing or in form of a facsimile or any other similar or electronic communication
means. The Directors may only act at duly convened meetings of the Board of Directors. Directors may not bind the
Company by their individual acts, except as specifically permitted by resolution of the Board of Directors.
The Board of Directors can deliberate or act with due authority if at least a majority of the Directors is present or
represented at such meeting. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the Directors present or represented
at such meeting.
Resolutions signed by all members of the Board of Directors will be as valid and effectual as if passed at a meeting duly
convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution and
may be evidenced by facsimile or any other similar or electronic communication means.
Art. 17. Minutes. The minutes of any meeting of the Board of Directors shall be signed by the Chairman or, in his
absence, by the chairman pro-tempore who presided at such meeting or by two (2) Directors.
Copies or extracts of such minutes which are to be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by
the Chairman or by the chairman pro-tempore of that meeting or by two (2) Directors or the secretary or an assistant
secretary.
133753
L
U X E M B O U R G
Art. 18. Power. The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration,
disposition and execution in the Company's interest. All powers not expressly restricted by law or by the present Articles
of Association to the general meeting of shareholders fall within the competence of the Board of Directors.
Art. 19. Delegation of Power. The Board of the Company may delegate its powers to conduct the daily management
and affairs of the Company (including the right to act as authorised signatory for the Company) and its powers to carry
out acts in furtherance of the corporate policy and purpose to one or several physical persons or corporate entities,
which need not be Directors, who shall have the powers determined by the Board of Directors and who may, if the
Board of Directors so authorizes, sub-delegate their powers.
The Board may also confer special powers of attorney by notarial or private proxy.
The Board may further decide to create either at the level of the Company or for a specific sub-fund any committee
the members of which need not be Directors. The Board shall organize such committee functioning and determine the
powers of their members as further described in the offering document of the Company.
Art. 20. Conflicts of Interest. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm
shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Directors or officers or agent or daily manager
or employee of the Company is interested in, or is a director, associate, officer, agent, daily manager or employee of such
other company or firm. Any Director, officer, agent, daily manager or employee of the Company who serves as a director,
officer, agent, daily manager or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise
engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering
and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.
In the event that any Director, officer, agent, daily manager or employee of the Company may have, in any transaction
of the Company, an interest opposite to the interests of the Company, such Director, officer, agent, daily manager or
employee shall make known to the Board of Directors such opposite interest and shall not consider or vote on any such
transaction, and such transaction and such Director's, officer's, agent's, daily manager's or employee's interest therein
shall be reported to the next succeeding general meeting of shareholders.
The term “opposite interest”, as used in the preceding sentence, shall not include any relationship with or interest in
any matter, position or transaction involving any person, company or entity as may from time to time be determined by
the Board of Directors in its discretion.
Art. 21. Signature. The Company shall be bound by the joint signature of any two (2) Directors or by the individual
signature(s) of any duly authorised Director or officer, or agent or daily manager of the Company or by the individual
signature of the Chairman or any other person(s) to whom authority has been delegated by the Board of Directors.
Art. 22. Indemnification. The Company will indemnify any Director, officer or member of any committee referred to
above and his heirs, executors and administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any
action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a Director, officer or
member of any committee of the Company or, at its request, of any other company of which the Company is a shareholder
or a creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be
finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct; in the event of a
settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which
the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing
right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.
Art. 23. General meetings of shareholders. The general meeting of shareholders of the Company shall represent the
entire body of shareholders of the Company. Its resolutions shall be binding upon all the shareholders of the Company.
It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.
If all shareholders are present or represented at the general meeting and state that they have been duly informed of
the agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice.
The general meeting of shareholders shall meet upon call by the Board of Directors. It may also be called upon the
written request of shareholders representing at least one tenth of the share capital.
Upon request of shareholders representing at least one tenth of the share capital, one or more new items shall be
added to the agenda of any general meeting of shareholders. Such demand shall be addressed to the registered office of
the Company by registered mail at least five (5) days before such meeting.
The annual meeting shall be held in accordance with Luxembourg law at the registered office of the Company or at
such other place as may be specified in the notice of meeting, on June 15
th
each year at 1:00 pm Luxembourg time. The
first annual meeting shall be held on June 15
th
in 2015.
If such day is a legal or bank holiday in Luxembourg, the annual meeting shall be held on the next banking day.
Other meetings of shareholders, including meetings of shareholders of one specific sub-fund or class of shares, may
be held at such places and times as may be specified in the respective notices of meeting.
The quorum and time-limits provided by law shall govern the convening notices and the conduct of the meetings of
shareholders of the Company unless otherwise provided herein.
133754
L
U X E M B O U R G
Any shareholder may participate in a general meeting of shareholders by video conference, or by conference call or
similar means of communication equipment which enables his/her identification and participating in a meeting by such
means shall constitute presence in person at such meeting. The means of communication used must allow all the persons
taking part in the meeting to hear one another on a continuous basis and must allow an effective participation of all such
persons in the meeting. The Board may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders in order to
attend any meeting of shareholders.
The business transacted at any meeting of the shareholders shall be limited to the matters contained in the agenda
(which shall include all matters required by law) and business incidental to such matters.
Each whole share of the Company is entitled to one vote, in compliance with Luxembourg law and these Articles of
Association. A shareholder may act at any meeting of shareholders by giving a proxy to another person in writing or by
facsimile transmission or any other similar or electronic communication means, who need not be a shareholder and who
may be a Director of the Company.
Unless otherwise provided by law or herein, resolutions of the general meeting are passed by a simple majority of the
votes validly cast, unless the item to be resolved upon relates to an amendment of the Articles, in which case the resolution
will be passed with a majority of the two thirds of the votes validly cast.
Art. 24. Financial Year. The Company's financial year begins on 1
st
January and closes on 31
st
December of the same
year.
Art. 25. Accounts. Each year, the Board of Directors will draw up the annual accounts of the Company. The annual
accounts shall be approved by the annual general meeting of shareholders upon proposal of the Board of Directors. The
accounts shall be expressed in Euro.
Art. 26. Supervision. The operations of the Company and its financial situation shall be supervised by one independent
auditor qualifying as a «réviseur d'entreprises agréé» who shall be appointed by the shareholders. The independent auditor
shall be remunerated by the Company and shall remain in office until its successor is appointed. The independent auditor
shall fulfill all duties prescribed by the 2007 Law.
Art. 27. Distribution. Subject to permitted reinvestments, and the requirements of Luxembourg law, distributions shall
be payable by the Company on its shares upon decision by the Board of Directors in accordance with the Company's
offering document.
No distribution may be made if after the declaration of such distribution the net asset value of the Company would
fall below EUR 1,250,000.- (one million two hundred fifty thousand Euro). Dividends not claimed within five years of their
due date will lapse and revert to the relevant class of shares.
Art. 28. Depositary Bank. The Company shall enter into a depositary bank agreement with a financial institution, which
shall satisfy the requirements of the 2007 Law and the 2013 Law. The depositary bank shall assume towards the Company
and the shareholders the responsibilities set out in the 2007 Law (notably in article 16 of the 2007 Law) and the 2013
Law, the depositary bank agreement and any other law applicable.
In the event of termination of the depositary bank agreement or the resignation of the depositary bank, the Board of
Directors shall use its best endeavors to find a financial institution to act as depositary bank and upon doing so the Board
of Directors shall appoint such financial institution to be depositary bank in place of the former depositary bank.
Art. 29. Liquidation. In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several
liquidators (whether natural persons or legal entities approved by the CSSF) named pursuant to a general meeting effecting
such dissolution and at which meeting the liquidators' powers and compensation shall be determined. The operations of
liquidation will be carried out pursuant to the 1915 Law.
The net proceeds of liquidation in respect of each sub-fund or, as the case may be, of each class within each sub-fund,
shall be distributed by the liquidators to the holders of shares of the relevant class in proportion to their holding of such
shares in such sub-fund or class, and whether such proceeds shall be distributed in cash or kind.
If the Company's share capital (i.e. the aggregate of all sub-funds) falls below two-thirds of the minimum capital (EUR
1,250,000.-), the Board of Directors must submit a proposal for the Company's termination to a general meeting for
deliberation. No quorum requirements will be applied; winding-up may be pronounced by a simple majority of the validly
cast votes.
If the Company's share capital falls below one quarter of the minimum capital increased by the share premium (EUR
1,250,000.-), the Board of Directors must submit a proposal for the Company's termination to the general meeting for
deliberation. No quorum requirements will be applied; winding-up may be pronounced by the shareholders owning one
quarter of the validly cast votes.
The aforesaid meetings shall be convened within forty days of the date at which it was ascertained that the net assets
fell below two-thirds or one quarter of the minimum capital, respectively.
Moreover, the Company may be terminated by resolution of the general meeting in accordance with the pertinent
provisions of these Articles of Association.
133755
L
U X E M B O U R G
The resolutions of the general meeting of shareholders or of a court of law pronouncing the termination and winding-
up of the Company are to be published in compliance with applicable laws. The choice of which newspapers are to carry
the publication is made at the discretion of the liquidator(s).
The amounts that have not been claimed by the shareholders or their beneficiaries at the close of liquidation of the
Company shall be deposited with the Caisse de Consignation in Luxembourg.
Art. 30. Termination, liquidation and merger of sub-funds or classes of shares. The Board of Directors may decide to
close one or more classes or sub-funds (having or not a limited duration) in the best interests of the shareholders, if there
has been a substantial modification in the political, economic, regulatory or monetary situation pertinent to a class or
sub-fund, which, in the opinion of the Board of Directors renders this decision necessary, or where such action is required
in order to protect the interests of shareholders, or if for any reason whatsoever, the value of the net assets of a sub-
fund falls below an amount determined in the Company's offering document and the Board of Directors determines that
the interests of the shareholders of that same class or sub-fund demand such action to be taken.
The Company shall serve a notice in writing to the shareholders of the relevant class or sub-fund, which will indicate
the reasons and the procedure for the redemption operations.
The Company shall base these redemptions on the net asset value taking into account liquidation expenses.
The amounts that have not been claimed by the shareholders or their beneficiaries at the close of liquidation of a class
or sub-fund shall be deposited with the Caisse de Consignation in Luxembourg.
All redeemed Shares may be cancelled.
A termination contemplated above may be combined with a contribution to one or several sub-fund(s) or class(es)
within the Company or to one or several other sub-fund(s) or class(es) of another undertaking for collective investment
(under the corporate or the contractual type form) in the best interests of the shareholders.
Where the undertaking for collective investment that will receive the contribution is a mutual fund (fonds commun
de placement), the decision to contribute will only be binding on shareholders who have agreed to make a contribution.
A sub-fund may exclusively be contributed to a foreign undertaking for collective investment with the unanimous
approval of the shareholders of the relevant sub-fund or under the condition that only the assets of the consenting
shareholders shall be so contributed.
Art. 31. Applicable Law. Reference is made to the provisions of the 1915 Law and the 2007 Law for which no specific
provision is made in these Articles of Association.
Art. 32. Definitions and Interpretation. References to articles are to the Articles of these Articles of Association.
Words importing gender include each gender. References to persons include bodies corporate, firms and unincorporated
associations. The singular includes the plural and vice versa. Headings of articles are included for convenience only and
do not affect their interpretation. References to all or any part of any statute or statutory instrument include any statutory
amendment, modification or re-enactment in force from time to time and references to any statute include any statutory
instrument or regulations made under it. Any reference to the Company, the Board of Directors, agents, etc, includes a
reference to its or their duly authorized agents or delegates.
<i>Transitional measuresi>
Exceptionally, the first financial year shall begin on the date hereof and end on 31
st
December 2014.
The first annual general meeting shall be held in June 15
th
, 2015.
<i>Subscription and Paymenti>
The initial capital of the Company amounts to thirty one thousand Euros (EUR 31,000.-) and has been subscribed as
follows:
Mandatum Life Insurance Company Limited: three hundred ten (310) shares of the share class “G EUR Share Class”
of the sub-fund of the Company “Mandatum Life Finland Equity Fund”.
The subscribed capital has been fully paid up in cash. The result is that as of now the company has at its disposal the
sum of thirty-one thousand Euros (EUR 31,000.-) as was certified to the notary executing this deed.
<i>Statementi>
The notary executing this notarial deed declares that he has verified the conditions laid down in the 1915 Law, and
confirms that these conditions have been observed.
<i>Estimate of formation expensesi>
The appearing parties declare that the expenses, costs and fees or charges of any kind whatsoever, which fall to be
paid by the Company as a result of its incorporation amount approximately to three thousand euro (EUR 3,000)
133756
L
U X E M B O U R G
<i>General meeting of shareholdersi>
The appearing parties, representing the entire subscribed share capital and considering themselves as having been duly
convened, immediately proceeded to hold a general meeting of the shareholders of the Company.
Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote
and with the approval of the Board of Directors:
<i>First resolution:i>
The following persons are elected as member of the Board of Directors for a period ending at the annual general
meeting of shareholders to be held on 15 June 2015:
- Mr Jukka Pirskanen, born on 16.3.1963 in Tampere, Finland, having professional address at Bulevardi 56, FI-00120
Helsinki, Finland;
- Mr Timo Vuokila, born on 8.4.1965 in Rovaniemi, having professional address at Bulevardi 56, FI-00120 Helsinki,
Finland;
- Ms Hanna Duer, born on 7.5.1966 in Gentofte, Denmark, having professional address at 370, route de Longwy,
L-1940 Luxembourg; and
- Ms Salla Komulainen, born on 30.4.1970 in Helsingin mlk, Finland, having professional address at 52, rue de Roden-
bourg, L-6950 Olingen, Luxembourg.
<i>Second resolutioni>
The address of the registered office of the Company is set at 26-28 Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg.
<i>Third resolutioni>
Has been elected as approved statutory auditor (réviseur d'entreprise agréé) until the annual general meeting of
shareholders to be held in 2015:
Ernst & Young,
7, Rue Gabriel Lippmann,
Parc d'Activité Syrdall
L-5365 Munsbach
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English only.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Esch/Alzette, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by surname, name, civil status and
residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.
Signé: Henryon, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette, Actes Civils, le 05 septembre 2014. Relation: EAC/2014/11881. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. Halsdorff.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2014150215/429.
(140171097) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2014.
Cana S.C.I., Société Civile.
Siège social: L-2116 Luxembourg, 9, rue de la Malterie.
R.C.S. Luxembourg E 680.
EXTRAIT
Il résulte d'un procès-verbal de la réunion de la gérance tenue en date du 12 août 2014 que:
La gérance décide de transférer le siège social de 1, rue des Anémones L-8023 Strassen à 9, rue de la Malterie L-2116
Luxembourg.
L'article 4 changera comme suit: Le siège social est établi à Luxembourg
Pour extrait sincère et conforme
Référence de publication: 2014128491/13.
(140146011) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2014.
133757
L
U X E M B O U R G
Mandatum Life Fund Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 190.624.
STATUTES
In the year two thousand and fourteen, on the second day of September,
Before Us, Maître Francis Kesseler, notary, residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg
There appeared the following:
Mandatum Life Insurance Company Limited, a company incorporated in Finland, having its registered office at Bulevardi
56, FI-00120 Helsinki, Finland, and under the supervision of the Finnish Financial Supervisory Authority,
here represented by Mrs Sophie Henryon, an employee having with professional address at 5, rue Zénon Bernard,
L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal, which shall remain
attached to these minutes in order to be registered with these
which proxy has been initialled “ne varietur” by the proxy holder and the undersigned notary will remain attached to
the present deed to be filed at the same time,
who has requested the undersigned notary to draw up as follows the deed of formation of a Luxembourg company
that it desires to incorporate and the articles of incorporation of which (the “Articles of Incorporation” or the “Articles”)
shall be as follows:
I. Name - Registered office - Duration - Object
Art. 1. Name. There is hereby formed among the subscriber, and all other persons who shall become owners of the
shares hereafter created, a société anonyme under the name of "Mandatum Life Fund Management S.A.” (hereafter the
“Company”).
Art. 2. Registered Office. The registered office of the Company is established in Luxembourg in the Grand Duchy of
Luxembourg. It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the
general meeting of shareholders (the “General Meeting of Shareholders”) deliberating in the manner provided for amend-
ments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the same municipality by simple resolution of the board
of directors of the Company (the “Board of Directors”).
If extraordinary events of political, economic or social nature likely to impair the normal activity at the registered office
or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned to normal. Such
a transfer will, however, have no effect on the nationality of the Company which shall remain a Luxembourg company.
The declaration of the provisional transfer abroad of the registered office will be made and brought to the attention of
third parties by the officer of the Company best placed to do so in the circumstances.
Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited duration.
Art. 4. Purpose. The purpose of the Company is the creation, promotion, administration and management of one or
several specialized investment funds (“fonds d’investissement spécialisés”) (the “Funds”) subject to the Luxembourg law
on specialized investment funds dated 13 February 2007 as amended from time to time and qualifying as alternative
investment funds (“AIF”) in the meaning of and in accordance with Directive 2011/61/EU on alternative investment fund
managers as amended from time to time and implemented into Luxembourg law by the law of 12 July 2013 on alternative
investment fund managers (the “Law of 2013”).
The Company shall carry out any activities connected with the management, administration and promotion of the
Funds in compliance with chapter 16 of the Luxembourg law of 17 December 2010 on undertakings for collective in-
vestment (the “Law of 2010”). It may, in its own name and on behalf of the Funds, enter into any contract, purchase, sell,
exchange and deliver any securities or real estate, proceed to any registration and transfer in its name or in third parties’
names in the register of units or debentures of any Luxembourg or foreign companies and exercise on behalf of the Funds
and holders of units of the Funds, all rights and privileges, including all voting rights attached to the securities constituting
the assets of the Funds. It may further in its own name and on behalf of the Funds grant loans, guarantees or any form of
collateral in relation to the above activities, excluding loans granted to holders of units of the Funds. The foregoing powers
shall not be considered as exhaustive, but only as declaratory.
Further, the Company’s object includes the management of AIFs.
The activity of management of AIFs includes the following functions:
Portfolio Management. In this regard, the Company may, for the account of the AIFs, (i) provide investment advice
and make investment decisions, (ii) enter into agreements, (iii) buy, sell, exchange and deliver any sort of transferable
securities and/or other acceptable types of assets, (iv) exercise all voting rights pertaining to securities held by the in-
vestment funds under management. This enumeration is not intended to be exhaustive.
133758
L
U X E M B O U R G
Risk Management. The activity of the management of the AIFs includes the risk management of the Funds, as mentioned
in Annex I of the Law of 2013.
Administration. The activity of the management of the AIFs includes the functions listed in Annex I of the Law of 2013,
i.e. (i) legal and fund management accounting services, (ii) customer inquiries, (iii) valuation of the portfolio and pricing
of the units and/or shares (including tax returns), (iv) regulatory compliance monitoring, (v) maintenance of unitholders
and/or shareholders register, (vi) distribution of income, (vii) units and/or shares issues and repurchases, (viii) contract
settlements (including certificate dispatch), and (ix) record keeping.
Distribution. The activity of the management of the AIFs includes the distribution, marketing and placement of the
units and/or shares of Funds in Luxembourg and abroad.
The Company may perform part or all of these activities for AIFs or other management companies or alternative
investment fund managers as delegate. The Company may provide services in Luxembourg and abroad and may for that
purpose establish representative offices and/or branches. The Company may also administer its own assets and perform
all operations and activities considered useful for the accomplishment and development of its purposes, while remaining
however within the limits laid down by the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended (the “Law of
1915”), by chapter 16 of the Law of 2010 (and notably by the Art. 125-2 of this law) and by the Law of 2013.
II. Share capital, Share premium, Shares
Art. 5. Share Capital. The Company has an issued and paid-up capital of 900.000,- euro divided into 900 shares with
a nominal value of 1,000,- euro per share, each fully paid-up.
The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a decision of the General Meeting of Share-
holders deliberating in the manner required for amendments to the Articles.
In addition to the corporate capital, there may be set up a share premium account into which any premium paid on
any share in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the
payment of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realized losses, to make
distributions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.
Art. 6. Shares. The shares of the Company shall be in registered form.
A register of shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any shareholder.
Ownership of shares will be established by inscription in the said register.
The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the law.
III. Management - Supervision
Art. 7. Appointment of the Board of Directors. The Company shall be managed by a Board of Directors composed
of three (3) members at least who need not be shareholders of the Company.
The directors shall be elected by a General Meeting of Shareholders for a period that may not exceed six years. The
directors may be dismissed at any time and at the sole discretion of a General Meeting of Shareholders. The directors
shall hold office until their successors are elected on the basis of a list of candidates proposed by the Board of Directors.
In the event of a vacancy in the office of a Director because of death, retirement or otherwise, the remaining Directors
may meet and elect, by majority vote, a Director to fill such vacancy until the next meeting of the shareholders.
Art. 8. Meetings of the Board of Directors. The Board of Directors will elect from among its members a Chairman.
It may further choose a Secretary, either director or not, who shall be in charge of keeping the minutes of the meetings
of the Board of Directors.
The Chairman will preside at all meetings of shareholders and of the Board of Directors. In his absence, the General
Meeting of Shareholders or, as the case may be, the Board of Directors will appoint another person as chairman pro
tempore by vote of the majority in number present in person or by proxy at such meeting.
Meetings of the Board of Directors are convened by the Chairman or by any other two members of the Board.
Written notice of any meeting of the Board of Directors shall be given to all Directors at least twenty-four (24) hours
in advance of the hour set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances
shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by cable, telegram,
telex or telefax or similar communication from each Director. Separate notice shall not be required for meetings held at
times and places set out in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors.
The meeting will be duly held without prior notice if all the directors are present or duly represented.
The meetings are held at the place, the day and the hour specified on the convening notice.
Any director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing or by facsimile or telegram or
telex another director as his proxy.
The internal regulations of the Board of Directors may provide that the directors participating in the board meeting
by video conference or any other telecommunication means allowing for their identification and effective participation
to the meeting shall be deemed present for the purpose of quorum and majority rules.
133759
L
U X E M B O U R G
Any director may participate in any meeting of the Board of Directors by conference call or by other similar means
of communication allowing all the persons taking part in the meeting to communicate with each other. The participation
in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The Board of Directors can deliberate or act with due authority if at least a majority of the Directors is present or
represented at such meeting. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the Directors present or represented
at such meeting. In cases when they are an even number of directors, the chairman of the meeting shall have a casting
vote.
A director having a personal interest contrary to that of the Company in a matter submitted to the approval of the
Board of Directors shall be obliged to inform the Board of Directors thereof and to have his declaration recorded in the
minutes of the meeting. He may not take part in the relevant proceeding of the Board. At the next General Meeting of
Shareholders, before votes are taken in any other matter, the shareholders shall be informed of those cases in which a
director had a personal interest contrary to that of the Company.
These rules do not apply when the Board of Directors votes on transactions, in which any director may have any
personal interest, if they are concluded in the ordinary course of business at arm’s length.
Resolutions signed by all directors shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly convened
and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be
evidenced by letter, facsimile or telex.
Art. 9. Minutes. The decisions of the Board of Directors will be recorded in minutes to be inserted in a special register
and signed by the Chairman or by any two other directors. Any proxies will remain attached thereto.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise, will be signed by the
Chairman or by any two other directors.
Art. 10. Powers. The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and
disposition in the Company's interest. All powers not expressly reserved by the Law of 1915 or by the present Articles
to the General Meeting of Shareholders fall within the competence of the Board of Directors.
Art. 11. Delegation of Powers. The Board of Directors may delegate part of its powers to at least two persons that
shall be of sufficiently good repute and that shall be sufficiently experienced also in relation to the type of business carried
out by the UCIs referred to under Article 4. These persons shall have full authority to act on behalf of the Company in
all matters concerned with the daily management and affairs of the Company, and to carry out all acts in furtherance of
the policy and purpose of the Company.
The Company shall be bound towards third parties by the joint signatures of two directors in all matters or the joint
signatures or single signature of any persons to whom such signatory power has been granted by the Board of Directors,
but only within the limits of such power.
Art. 12. Indemnification. The Company may indemnify any director or officer and his heirs, executors and adminis-
trators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may
be made a party by reason of his being or having been a director or officer of the Company or, at his request, of any
other company of which the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified,
except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for
gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with
such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified
did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he
may be entitled.
Art. 13. Authorised independent external auditor. The operations and books of the Company shall be supervised by
an authorized independent external auditor. The authorized independent external auditor shall be elected by the annual
General Meeting of Shareholders for a period ending at the date of the next annual General Meeting of Shareholders until
his successor is elected. The authorized independent external auditor shall remain in office until he is reelected or until
his successor is elected.
IV. General meetings of shareholders
Art. 14. Powers of the General Meetings of Shareholders. The General Meeting of Shareholders properly constituted
represents the entire body of shareholders. It has the powers conferred upon it by law.
Art. 15. Annual General Meeting of Shareholders - Other General Meetings of Shareholders. The annual General
Meeting of Shareholders shall be held at the registered office of the Company, or at such other place as may be specified
in the notice of meeting, on the fifteenth day of May of each year at 1.00pm and for the first time in 2015.
If such day is a not a business day, the annual General Meeting of Shareholders shall be held on the next following
business day. The annual General Meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the Board of
Directors, exceptional circumstances so require.
Other General Meetings of Shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective
notices of meeting.
133760
L
U X E M B O U R G
Art. 16. Proceedings, Vote. General Meetings of Shareholders shall meet upon call of the Board of Directors or, if
exceptional circumstances require so, by any two directors acting jointly.
It shall be necessary to call a General Meeting of Shareholders whenever a group of shareholders representing at least
one tenth of the subscribed capital requires so. In such case, the concerned shareholders must indicate the agenda of the
meeting.
Shareholders will meet upon call by registered letter on not less than 8 days prior notice.
All notices calling General Meetings of Shareholders must contain the agenda for such meetings.
If all shareholders are present or represented at the General Meeting and if they state that they have been duly informed
on the agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice.
Any shareholder may act at any General Meeting by appointing in writing or by facsimile, cable, telegram or telex as
his proxy another person who need not be shareholder.
The Board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in a General
Meeting of Shareholders.
The shareholders participating in a meeting of shareholders by video conference or any other telecommunication
means allowing for their identification and for effective participation in the meeting shall be deemed present for the
purpose of quorum and majority rules.
Each share entitles its shareholder to one vote.
Except as otherwise required by law, resolutions at a General Meeting of Shareholders duly convened will be passed
by a simple majority of the shareholders present and voting, without any quorum requirements.
Before commencing any deliberations, the chairman of the General Meeting shall appoint a secretary and the share-
holders shall appoint a scrutineer. The chairman, the secretary and the scrutineer form the Meeting’s Board.
The minutes of the General Meeting will be signed by the members of the Meeting’s Board and by any shareholder
who wishes to do so.
However, in case decisions of the General Meeting have to be certified, copies or extracts for use in court or elsewhere
must be signed by the Chairman of the Board of Directors or any two other directors.
V. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits
Art. 17. Financial Year. The accounting year of the Company shall begin on January 1
st
of each year and shall terminate
on December 31
st
, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the
Company and shall terminate on December 31
st
, 2014.
Art. 18. Annual Accounts. Each year, at the end of the financial year, the Board of Directors will draw up the annual
accounts of the Company in the form required by law.
Art. 19. Allocation of Profits. The credit balance on the profit and loss account, after deduction of the general expenses,
social charges, write-offs and provisions for past and future contingencies as determined by the Board of Directors,
represents the net profit.
Every year five per cent of the net profit will be set aside in order to build up the legal reserve. This deduction ceases
to be compulsory when the legal reserve amounts to one tenth of the issued share capital.
The remaining balance of the net profit shall be at the disposal of the General Meeting of Shareholders.
Dividends, when payable, will be distributed at the time and place fixed by the Board of Directors within the limits of
the decision of the General Meeting.
The Board of Directors may decide to pay interim dividends within the conditions provided for by law.
The General Meeting may decide to assign profits and distributable reserves to the reimbursements of the capital
without reducing the corporate capital.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 20. Dissolution. The Company may be dissolved at any time by decision of the General Meeting of Shareholders
deliberating in the manner required for amendments to the Articles.
Art. 21. Liquidation. In the event of the dissolution of the Company, the General Meeting, deliberating in the manner
required for amendments to the Articles, will determine the method of liquidation and nominate one or several liquidators
and determine their powers.
VII. General provision
Art. 22. Governing Law. All matters not governed by the present Articles shall be determined in accordance with the
provisions of the Law of 1915 as amended from time to time, with the Law of 2010 as amended from time to time and
with the Law of 2013 as amended from time to time.
133761
L
U X E M B O U R G
<i>Subscription and paymenti>
The Shares have been subscribed and issued as follows:
Mandatum Life Insurance Company Limited, hereabove mentioned, has subscribed to 900 Shares with a par value of
EUR 1,000.- each, fully paid up.
As a consequence the Company has at its disposal an amount of EUR 900,000.- of which evidence has been shown to
the undersigned notary who expressly states this.
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
The appearing party, represented as stated above, representing the entire subscribed capital, takes the following re-
solutions:
<i>First resolutioni>
The following persons are elected as members of the Board of Directors for a period ending at the annual General
Meeting of Shareholders to be held in 2015:
- Mr Timo Laitinen, born on 8.9.1959 in Helsinki, Finland, having professional address at Bulevardi 56, FI-00120 Helsinki,
Finland;
- Ms Hanna Duer, born on 7.5.1966 in Gentofte, Denmark, having professional address at 370, route de Longwy,
L-1940 Luxembourg; and
- Ms Salla Komulainen, born on 30.4.1970 in Helsingin mlk, Finland, having professional address at 52, rue de Roden-
bourg, L-6950 Olingen, Luxembourg.
<i>Second resolutioni>
Has been elected as auditor until the annual General Meeting of Shareholders to be held in 2015:
Ernst & Young,
7, Rue Gabriel Lippmann,
Parc d'Activité Syrdall
L-5365 Munsbach
<i>Third resolutioni>
The registered office of the Company shall be at 26-28 Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its organisation are estimated at approximately three thousand euro (EUR 3,000.-).
<i>Attestationi>
The Notary acting in this matter declares that he has checked the existence of the conditions set out in Articles 26
of the Law on Commercial Companies and expressly attests that they have been complied with.
Whereof, this notarial deed was drawn up in Esch/Alzette, on the day specified at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,
this deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing parties and in case
of divergence between the English and the French text, the English version shall prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing person known to the notary by name, first name,
and residence, the said proxyholder of the appearing person signed together with the notary this deed.
Suit la traduction française:
L'an deux mille quatorze, le deux septembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand Duché de Luxembourg
A comparu:
Mandatum Life Insurance Company Limited, établie en Finlande, ayant son siège social au Bulevardi 56, FI-00120 Hel-
sinki, Finlande, et soumise à la surveillance de la Financial Supervisory Authority de Finlande,
ici représentée par Mme Sophie Henryon, une employée ayant son adresse professionnelle au 5, rue Zénon Bernard,
L-4030 Esch-sur-Alzette en vertu d'une procuration sous seing privé qui restera annexée au présent acte aux fins d'en-
registrement;
Dont la procuration paraphée «ne varietur» par le comparant et le notaire soussigné restera annexée au présent acte
aux fins d’enregistrement,
lequel comparant a requis le notaire soussigné de dresser l’acte de constitution d'une société luxembourgeoise qu'il
souhaite constituer et dont le texte des statuts (les "Statuts") est comme suit:
133762
L
U X E M B O U R G
I. Dénomination - Siège social - Durée - Objet
Art. 1
er
. Dénomination. Il est formé entre le comparant et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-
après créées, et de celles qui pourront être créées à l’avenir, une société anonyme de droit luxembourgeois, ci-après
dénommée «la Société», qui sera régie par les lois en vigueur et les présents statuts.
La société adopte la dénomination de Mandatum Life Fund Management S.A. (ci-après la “Société”).
Art. 2. Siège social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg. Il peut être transféré en tout autre endroit
du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l’assemblée générale des actionnaires («l’Assemblée Générale
des Actionnaires») statuant comme en matière de changement des Statuts.
L’adresse du siège social peut être déplacée dans les limites de la commune par simple décision du conseil d’adminis-
tration de la Société (le «Conseil d’Administration»).
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité
normale au siège ou la communication aisée entre ce siège et les pays étrangers, se produiront ou seront imminents, le
siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu'à cessation complète des circonstances anormales. Ce
transfert n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle restera une société luxembourgeoise. La
déclaration de transfert provisoire du siège social à l’étranger sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe
de la Société le mieux placé pour ce faire suivant les circonstances.
Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Objet social. L’objet de la Société est la création, la promotion, l’administration et la gestion d'un ou de plusieurs
fonds d'investissement spécialisés (le ou les «Fonds») soumis à la loi luxembourgeoise sur les fonds d'investissement
spécialisés du 13 Février 2007 telle que modifiée et qualifiant de fonds d’investissements alternatifs («FIA») au sens de et
conformément à la Directive 2011/61/UE relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, telle qu'elle
pourra être modifiée de temps à autre et telle que transposée au Luxembourg par la loi du 12 juillet 2013 sur les
gestionnaires de fonds alternatifs (la «Loi de 2013»).
La Société procède à toute activité liée à la gestion, l’administration et la promotion des Fonds en conformité avec le
chapitre 16 de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placements collectif (la «Loi de 2010»). Elle peut,
en son nom propre et au nom du Fonds, conclure tout contrat, acheter, vendre, échanger et délivrer toutes valeurs
mobilières ou immobilières, procéder à tout enregistrement et tout transfert en son nom ou au nom de tiers dans le
registre des actionnaires ou des dettes d'une société luxembourgeoises ou étrangère et à l’exercice pour le compte des
Fonds et les porteurs de parts des Fonds, de tous les droits et privilèges, y compris tous les droits de vote attachés aux
titres constituant l’actif du Fonds. Elle peut en outre en son nom propre et au nom du Fonds conclure des prêts, garanties
ou toute autre forme de sûretés par rapport aux activités susmentionnées, à l’exclusion des prêts accordés aux détenteurs
de parts du Fonds. Les pouvoirs qui précèdent ne doivent pas être considérée comme exhaustifs, mais comme déclara-
toire.
De plus, l’objet de la Société inclut la gestion de FIAs.
L’activité de gestion de FIA inclut les fonctions suivantes:
Gestion d’actifs. A cet égard, la Société pourra, pour le compte des FIA, (i) fournir des conseils en investissement et
prendre des décisions d’investissement, (ii) conclure des contrats, (iii) acheter, vendre, échanger et délivrer toute sorte
de valeurs mobilières et/ou autres types d’actifs autorisés, (iv) exercer tous les droits de vote en relation avec les titres
détenus par les fonds d’investissement sous gestion. Cette énumération n’est pas destinée à être exhaustive.
Gestion des risques. L’activité de gestion des FIA inclut la fonction de gestion des risques des Fonds, tel que prévu par
l’Annexe 1 de Loi de 2013.
Administration. L’activité de gestion des FIA inclut les fonctions telles que listées en Annexe I de la Loi de 2013, c’est
à dire (i) services juridiques et de gestion comptable du fonds, (ii) demande de renseignement des clients, (iii) évaluation
du portefeuille et détermination de la valeur des parts et/ou actions (y compris les aspects fiscaux), (iv) contrôle du respect
des dispositions réglementaires, (v) tenue du registre des porteurs de parts et/ou actionnaires, (vi) répartition des revenus,
(vii) émission et rachat de parts et/ou d’actions, (viii) règlement des contrats (y compris envoi des certificats), et (ix)
enregistrement et conservation des opérations.
Distribution. L’activité de gestion des FIA inclut la commercialisation, la distribution et le placement des parts et/ou
actions des Fonds à Luxembourg et à l’étranger.
La Société peut exercer tout ou partie de ces activités pour des FIA ou pour d’autres sociétés de gestion ou gestion-
naires de fonds d’investissement alternatifs comme délégataire. La Société peut fournir ces services à Luxembourg ainsi
qu'à l’étranger et peut pour ce faire établir des bureaux de représentation ou des succursales. La Société peut également
administrer ses propres actifs et entreprendre toutes opérations et activités considérées comme utiles à l’accomplisse-
ment et au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales telle que modifiée (la «Loi de 1915»), par le chapitre 16 de la Loi de 2010 (et notamment par l’Art. 125-2
de cette loi) et par la Loi de 2013.
133763
L
U X E M B O U R G
II. Capital social - Actions
Art. 5. Capital social. La Société a un capital souscrit et libéré de 900.000,- euro divisé en 900 actions, ayant chacune
une valeur nominale de 1.000 euro par action, chacune étant complètement libérée. Le capital social de la Société peut
être augmenté ou réduit par une décision de l’Assemblée Générale des Actionnaires statuant comme en matière de
changement des Statuts.
En plus du capital social, un compte de prime d’émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une ou
plusieurs actions en plus de la valeur nominale seront transférées. L’avoir de ce compte de prime peut être utilisé pour
effectuer le remboursement en cas de rachat par la Société d’actions des actionnaires, pour compenser des pertes nettes
réalisées, pour effectuer des distributions aux actionnaires ou pour allouer des fonds à la réserve légale.
Art. 6. Actions. Les actions de la Société sont nominatives.
Un registre des actions sera tenu au siège social de la Société, où il pourra être consulté par chaque actionnaire. La
propriété des actions sera établie par inscription dans ledit registre.
La Société peut racheter ses propres actions dans les limites prévues par la loi.
III. Administration - Surveillance
Art. 7. Nomination et révocation des administrateurs. La Société est administrée par un Conseil d’Administration
comprenant au moins [trois] membres, actionnaires ou non.
Les administrateurs seront nommés par l’Assemblée Générale des Actionnaires pour un terme ne pouvant excéder
six ans. Les administrateurs pourront être révoqués à tout moment et à la seule discrétion de l’Assemblée Générale des
Actionnaires. Les administrateurs resteront en poste jusqu'à l’élection de leur(s) successeur(s) faite sur base d'une liste
de candidatures proposées par le Conseil d'Administration.
En cas de vacance d’un poste d’administrateur pour cause de décès, démission ou toute autre cause, les administrateurs
restants peuvent se réunir et peuvent élire à la majorité un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste
vacant jusqu'à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires.
Art. 8. Réunion du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration élit un Président parmi ses membres. Il peut
en outre désigner un secrétaire, administrateur ou non, qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions
du Conseil d’Administration.
Le Président présidera toutes assemblées des actionnaires et toutes réunions du Conseil d’Administration. En son
absence, l’Assemblée Générale des Actionnaires, respectivement le Conseil d’Administration choisira une autre personne
en tant que président pro tempore par vote à la majorité des membres présents ou représentés à cette réunion.
Les réunions du Conseil d’Administration sont convoquées par le Président ou, à son défaut, par deux autres membres
du Conseil.
Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre
(24) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence
seront mentionnés dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment
par écrit, par câble, par télégramme ou par télex ou par un moyen de communication similaire de chaque administrateur.
Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date ou à un endroit déterminés dans
une résolution préalablement adoptée par le conseil d’administration.
La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les administrateurs sont présents ou dûment
représentés.
Les réunions sont tenues aux lieux, jour et heure spécifiés sur la convocation.
Chaque administrateur peut agir à une réunion du Conseil d’Administration en nommant comme son mandataire un
autre administrateur par lettre, téléfax, télégramme ou télex.
Le règlement intérieur du conseil d’administration peut prévoir que sont réputés présents pour le calcul de quorum
et de la majorité les administrateurs qui participent à la réunion par visio-conférence ou par des moyens de télécommu-
nication permettant leur identification et leur participation effective à la réunion.
Les administrateurs peuvent participer aux réunions du Conseil d’Administration par conference call ou par tout autre
moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant au conseil puissent communiquer
les unes avec les autres. Dans ce cas, le ou les membres concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion.
Le Conseil d’Administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée. Toutes décisions devront être prises à la majorité des votes des administrateurs présents ou représentés
lors d'une telle réunion. En cas de partage des voix, le Président aura la voix prépondérante.
Un administrateur ayant un intérêt personnel contraire à celui de la Société dans une matière soumise à l’accord du
Conseil d’Administration sera obligé d’en informer le Conseil d’Administration et il en sera fait état dans le procès-verbal
de la réunion. Il ne pourra participer à cette délibération du Conseil. A la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires,
avant tout autre vote, les actionnaires seront informés des cas dans lesquels un administrateur avait un intérêt personnel
contraire à celui de la Société.
133764
L
U X E M B O U R G
Ces règles ne sont pas applicables aux décisions du Conseil qui concernent les transactions dans lesquelles un admi-
nistrateur a un intérêt personnel, lorsqu'il s’agit des transactions courantes conclues dans des conditions normales.
Les résolutions signées par tous les administrateurs produisent les mêmes effets que les résolutions prises à une réunion
du Conseil d’Administration dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique
ou sur des copies multiples d’une résolution identique et peuvent résulter de lettres, téléfax ou télex.
Art. 9. Décisions du Conseil d’Administration. Les délibérations du Conseil d’Administration sont constatées par des
procès-verbaux insérés dans des registres spéciaux et signés par le Président ou par deux autres administrateurs. Toutes
procurations y resteront annexées.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président ou par deux
autres administrateurs.
Art. 10. Pouvoirs du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus larges pour
accomplir tous les actes d’administration et de disposition dans l’intérêt de la Société. Tous pouvoirs non expressément
réservés par la Loi de 1915, telle que modifiée, ou par les présents statuts à l’Assemblée Générale des Actionnaires sont
de la compétence du Conseil d’Administration.
Art. 11. Délégation de pouvoirs. Le Conseil d’Administration peut déléguer pour partie ses pouvoirs à au moins deux
personnes ayant une honorabilité et une expérience suffisantes pour le type d’activités mené par les OPC auxquels il est
fait référence au point 4. Ces personnes ont pleins pouvoirs pour agir au nom de la Société pour tout ce qui concerne
la gestion journalière et l’exécution d'opérations de la Société, ainsi que pour accomplir tout acte en vue de l’accomplis-
sement de l’objet et la poursuite de l’orientation générale de la Société.
La Société est engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux administrateurs,
ou les signatures conjointes ou uniques de tous fondés de pouvoir spéciaux auxquels de tels pouvoirs de signature ont
été conférés par le Conseil d’Administration, ceci uniquement dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.
Art. 12. Indemnisation. La Société peut indemniser tout administrateur ou directeur et ses héritiers, exécuteurs et
administrateurs testamentaires pour des dépenses raisonnablement encourues par lui en rapport avec toute action, pro-
cès ou procédure à laquelle il sera impliqué en raison du fait qu'il a été ou qu'il est un administrateur ou directeur de la
Société ou, à la requête de toute autre société de laquelle la Société est actionnaire ou créancière et de laquelle il n’est
pas en droit d’être indemnisé, excepté en relation avec des affaires dans lesquelles il sera finalement jugé responsable de
faute grave ou de mauvaise gestion; en cas d’arrangement, l’indemnisation sera seulement réglée en relation avec les
affaires couvertes par l’arrangement et pour lesquelles la Société obtient l’avis d’un conseiller que la personne qui doit
être indemnisée n’a pas failli à ses devoirs de la manière visée ci-dessus. Le précédant droit d’indemnisation n’exclut pas
d’autres droits auxquels il a droit.
Art. 13. Réviseur d'entreprises indépendant agréé. Les opérations de la Société, comprenant notamment la tenue de
sa comptabilité, seront surveillées par un réviseur d’entreprises agréé. Le réviseur d’entreprises agréé sera élu par l’As-
semblée Générale annuelle des Actionnaires pour une période prenant fin le jour de la prochaine Assemblée Générale
des Actionnaires et jusqu'à l’élection de son successeur. Le réviseur d’entreprises agréé restera en fonction jusqu'à la
réélection ou l’élection de son successeur.
IV. Assemblées Générales des Actionnaires
Art. 14.- Pouvoirs de l’Assemblée Générale des Actionnaires. L’Assemblée Générale des Actionnaires régulièrement
constituée représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi.
Art. 15. Assemblée Générale annuelle des Actionnaires - Autres Assemblées Générales. L’Assemblée Générale an-
nuelle des actionnaires se réunit au siège social de la Société ou à un autre endroit de la commune du siège social indiqué
dans les convocations, le 15 du mois de mai de chaque année à 13h00 et pour la première fois en 2015.
Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, l’Assemblée Générale annuelle des Actionnaires se réunit le premier jour ouvrable
qui suit. L’Assemblée Générale annuelle peut être tenue à l’étranger si suivant l’appréciation souveraine du Conseil d’Ad-
ministration, des circonstances exceptionnelles l’exigent.
D’autres Assemblées Générales des Actionnaires peuvent être tenues aux lieux et heures spécifiés dans les convoca-
tions respectives.
Art. 16. Procédure et vote. Les Assemblées Générales des Actionnaires sont convoquées par le Conseil d’Adminis-
tration ou, si des circonstances exceptionnelles l’exigent, par deux administrateurs agissant conjointement.
Une Assemblée Générale des Actionnaires devra être convoquée lorsqu'un groupe d’actionnaires représentant au
moins un dixième du capital souscrit le requiert. Dans ce cas, les actionnaires concernés devront spécifier l’ordre du jour.
Les convocations aux Assemblées Générales des Actionnaires sont faites par lettre recommandée avec un préavis d’au
moins 8 jours.
Les convocations doivent contenir l’ordre du jour de l’assemblée.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour soumis
à leurs délibérations, l’Assemblée Générale peut avoir lieu sans convocations préalables.
133765
L
U X E M B O U R G
Tout Actionnaire pourra prendre part aux assemblées des Actionnaires en désignant par écrit ou par message télé-
copié, câble, télégramme ou télex une autre personne, qui n'a pas besoin d'être un actionnaire, comme son mandataire.
Le Conseil d’Administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les Actionnaires pour prendre
part à toute Assemblée Générale des Actionnaires.
Les actionnaires participant à une assemblée des actionnaires par visio-conférence ou par des moyens de télécom-
munication permettant leur identification et leur participation effective à l’assemblée seront réputés présents pour le
calcul de quorum et de la majorité.
Chaque action donne droit à une voix.
Excepté dans les cas prévus par la loi, les résolutions des Assemblées Générales des actionnaires dûment convoquées
seront valablement prises par la majorité simple des actionnaires présents et votants, sans qu'un quorum ne soit requis.
Avant d'engager les délibérations, le président de l’Assemblée Générale nomme un secrétaire et les actionnaires
désignent un scrutateur. Le président, le secrétaire et le scrutateur forment le Bureau de l’Assemblée.
Les procès-verbaux de l’Assemblée Générale seront signés par les membres du Bureau et par tout actionnaire qui en
fait la demande.
Cependant et au cas où des décisions de l’Assemblée Générale doivent être certifiées, des copies ou extraits de ces
procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président du Conseil d’Administration ou par deux
autres administrateurs.
V. Année sociale - comptes annuels - répartition des bénéfices
Art. 17. Année sociale. L’année sociale de la Société commence le 1
er
Janvier et finit le 31 Décembre de chaque année,
à l’exception de la première année sociale qui commencera le jour de la création de la Société et finira le 31 Décembre
2014.
Art. 18. Comptes annuels. Chaque année, à la fin de l’année sociale, le Conseil d’Administration dressera les comptes
annuels de la Société dans la forme requise par la loi.
Art. 19. Répartition des bénéfices. Le bénéfice net est représenté par le solde créditeur du compte des profits et pertes
après déduction des dépenses générales, des charges sociales, des amortissements et provisions pour risques passés et
futurs, tels que déterminés par le Conseil d’Administration.
Chaque année le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent à la formation ou à l’alimentation de la
réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve légale atteint dix pour cent du capital social.
L’Assemblée Générale décide souverainement de l’affectation du solde.
Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le Conseil d’Admi-
nistration dans les limites fixées par l’Assemblée Générale.
Le Conseil d’Administration est autorisé à distribuer des acomptes sur dividendes en observant les prescriptions
légales.
L’Assemblée Générale peut décider d’affecter des bénéfices et des réserves distribuables au remboursement du capital
sans réduire le capital social.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 20. Dissolution. La Société peut être dissoute en tout temps par une décision de l’Assemblée Générale des
actionnaires prise conformément aux conditions exigées pour une modification des Statuts.
Art. 21. Liquidation. En cas de dissolution de la Société, l’Assemblée Générale, en délibérant conformément aux con-
ditions exigées pour les modifications des Statuts, décidera du mode de liquidation et nommera un ou plusieurs
liquidateurs et déterminera leurs pouvoirs.
VII. Disposition générale
Art. 22. Pour tous les points qui ne sont pas régis par les présents Statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la Loi de 1915 ainsi que celles de la Loi de 2010 et de la Loi de 2013.
<i>Souscription et paiementi>
Les Actions ont été souscrites et émises comme suit:
Mandatum Life Insurance Company Limited, ci-avant désignée, a souscrit 900 Actions avec une valeur nominale de
1.000 euro libérées entièrement.
En conséquence, la Société a à sa disposition un montant de EUR 900,000, ce dont la preuve a été rapportée au notaire
soussigné, qui le constate expressément.
<i>Résolutions de l’actionnaire uniquei>
Le comparant, représenté comme indiqué ci-dessus, représentant l’entièreté du capital souscrit, prend immédiatement
les résolutions suivantes:
133766
L
U X E M B O U R G
<i>Première résolutioni>
Les personnes suivantes sont nommées membres du Conseil d'Administration pour une durée qui viendra à expiration
lors de l’Assemblée Générale annuelle ordinaire qui se tiendra en 2015:
- Monsieur Timo Laitinen, né le 8.9.1959 à Helsinki, Finlande, avec adresse professionnelle à Bulevardi 56, FI-00120
Helsinki, Finlande;
- Madame Hanna Duer, née le 7.5.1966 à Gentofte, Danemark, avec adresse professionnelle á 370, route de Longwy,
L-1940 Luxembourg; et
- Madame Salla Komulainen, née le 30.4.1970 à Helsingin mlk, Finlande, avec adresse professionnelle à 52, rue de
Rodenbourg, L-6950 Olingen, Luxembourg.
<i>Deuxième résolutioni>
A été nommé réviseur d'entreprises jusqu'à l’Assemblée Générale annuelle ordinaire qui se tiendra en 2015:
Ernst & Young
7, Rue Gabriel Lippmann,
Parc d’Activité Syrdall
L-5365 Munsbach
<i>Troisième résolutioni>
Le siège social de la Société est fixé au 26-28 Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg.
<i>Dépensesi>
Le comparant déclare que les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature, à charge de la Société des suites
de sa constitution s'élèvent à environ trois mille euros (EUR 3.000).
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés
commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
Le notaire soussigné, lequel connaît la langue anglaise constate que sur demande du comparant le présent acte est
rédigé en anglais suivi d'une version française. A la demande du même comparant et en cas de divergences entre la version
anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette, date qu'en tête, et après lecture faite au comparant, connu du notaire par
son nom, prénom, état civil et demeure, le comparant a signé avec le notaire le présent original.
Signé: Henryon, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette, Actes Civils, le 05 septembre 2014. Relation: EAC/2014/11883. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. Halsdorff.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2014152944/528.
(140174341) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2014.
b-to-v Private Equity S.C.S., SICAR, Société en Commandite simple sous la forme d'une Société d'Inves-
tissement en Capital à Risque.
Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 125.584.
<i>Auszug aus dem Protokoll der Außerordentlichen Generalversammlung der b-to-v Private Equity S.C.S., SICAR die am 30. Juni 2014i>
<i>in Munsbach stattfand:i>
Gemäß Artikel 3 der Satzung der b-to-v Private Equity S.C.S., SICAR beschließt die Außerordentliche Generalver-
sammlung die zweite Verlängerung der Laufzeit der Gesellschaft um ein Jahr. Die Laufzeit der Gesellschaft endet somit
am 31. Dezember 2015.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 30. Juli 2014.
<i>Für die b-to-v Private Equity S.C.S., SICAR
i>Die Zentralverwaltungsstelle:
Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services S.A.
Référence de publication: 2014127584/18.
(140144736) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2014.
133767
L
U X E M B O U R G
Airtime Projects, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7307 Steinsel, 50, rue Basse.
R.C.S. Luxembourg B 169.741.
<i>Extrait de la cession de parts sociales du 18 juillet 2014i>
Il résulte d'une cession de parts sociales sous seing privé du 18 juillet 2014 que les cinq cents (500) parts de la société
à responsabilité limitée Airtime Projects, détenues par Madame Anita Latsis, domiciliée au 37 Portman Towers, Georges
Street, London W1H 7HN (UK) ont été cédées en totalité à la société Sete Holdings S.à r.l., immatriculée au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B166382, ayant son siège social au 5, rue Jean Monnet,
L-2180 Luxembourg.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2014127601/14.
(140144449) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2014.
international quiding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9237 Dierkirch, 3, place Guillaume.
R.C.S. Luxembourg B 171.851.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion des associés tenue en date du 7 août 2014 à 10.00 heures au siège social de la sociétéi>
Constatation de la nouvelle adresse des associés comme suit:
«RIHOLD S.à r.l.», avec siège social à L-9237 Diekirch, 3, place Guillaume et inscrite auprès du Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le n° B 179 269. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50.000
«AUHOLD S.à r.l.», avec siège social à L-9237 Diekirch, 3, place Guillaume et inscrite auprès du Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le n° B 179 268. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 000
Total: cent mille parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000
Diekirch, le 7 août 2014.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Les associési>
Référence de publication: 2014127588/17.
(140144729) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2014.
eBay International AG (Luxembourg branch), Succursale d'une société de droit étranger.
Adresse de la succursale: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 165.452.
<i>Conseil d'administration:i>
La société eBay International A.G. prend acte de la démission de Monsieur Jacob Aqraou de son mandat d'adminis-
trateur de la société eBay International A.G., avec effet au 30 juin 2014.
En conséquence de quoi, le conseil d'administration de la société eBay International A.G. se compose dorénavant
comme suit:
- M. Devin Wenig, administrateur;
- M. Alexander van Schirmetster, administrateur;
- M. Jae Lee, administrateur;
- M. Mark Ineichen, administrateur;
- M. Anthony Charles Glasby, administrateur; et
- M. Patrick Kolek, administrateur.
Pour extrait, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 08. Aug. 2014.
eBay International A.G.
Pascal Marti / Jonathan Crowther
<i>Legal Manager Europe / Director, Indirect Taxesi>
Référence de publication: 2014127586/23.
(140144936) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2014.
133768
L
U X E M B O U R G
HBM BioCapital II Invest, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1748 Findel, 7, rue Lou Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 176.361.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juillet 2014.
Andreas Demmel.
Référence de publication: 2014124325/10.
(140138660) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
août 2014.
I-Real S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5730 Aspelt, 10, Munnereferstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 121.059.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Signature.
Référence de publication: 2014124341/10.
(140138489) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
août 2014.
JP Advice S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis.
R.C.S. Luxembourg B 173.147.
<i>Extrait du procès-verbal des résolutions prises par l'administrateur unique en date du 17 juillet 2014i>
L'administrateur unique a décidé de transférer le siège social de la Société du 24, rue des Genêts, L-1621 Luxembourg
au 2, rue du Fort Wallis, L-2714 Luxembourg, avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014125673/11.
(140142789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2014.
VR Netze Luxemburg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 50.000,00.
Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 116.950.
<i>Cession de parts socialesi>
Il résulte d'un contrat de transfert de parts, signé en date du 27 mai 2014, que l'associé unique de la Société, VR Netze
GmbH, a transféré la totalité des 400 parts sociales, d'une valeur nominale de EUR 125 chacune, qu'il détenait dans la
Société à:
(1) GAD eG, une eingetragene Genossenschaft constituée et régie selon les lois de l'Allemagne, ayant son siège social
à l'adresse suivante GAD-Straße 2-6, 48163 Münster, Allemagne, enregistrée auprès du Genossenschaftsregister Amts-
gerichts Münster sous le numéro GenR 337.
Les parts de la Société sont désormais réparties comme suit:
1. GAD eG: 400 parts sociales
Luxembourg, le 8 août 2014.
<i>Pour la Société
i>Joe Zeaiter
<i>Signataire autoriséi>
Référence de publication: 2014127582/21.
(140144349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2014.
133769
L
U X E M B O U R G
Hotel Group Maas, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.
R.C.S. Luxembourg B 177.512.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014124332/9.
(140138439) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
août 2014.
ICI Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4830 Rodange, 4, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 165.641.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014124360/9.
(140138645) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
août 2014.
Koch Chemical Technology LP1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 390.518.209,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 131.224.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2013 de la Société, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rap-
portent, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 31 juillet 2014.
Pour extrait conforme
ATOZ
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Signature
Référence de publication: 2014124418/17.
(140137453) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
août 2014.
Borrow Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 14, avenue du Dix Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 178.703.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires en date du 30 juillet 2014i>
Il résulte des résolutions de l'Assemblée Générale des actionnaires que:
L'assemblée générale renouvelle, pour une durée d'un an, les mandats d'administrateurs de Madame Simone Retter,
de Monsieur Jean-Paul Goerens, et de Madame Paola Pagliasso. Ces mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale
qui sera tenue en 2015 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.
L'assemblée générale renouvelle, pour une durée d'un an, le mandat de commissaire aux comptes de la société Lux
Fiduciaire Consulting S.à.r.l. Ce mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale qui sera tenue en 2015 pour statuer
sur les comptes de l'exercice
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 juillet 2014.
BORROW INVESTMENT S.A.
Simone Retter
Référence de publication: 2014125335/19.
(140143502) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2014.
133770
L
U X E M B O U R G
AGR Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3320 Berchem, 39, route de Bettembourg.
R.C.S. Luxembourg B 66.575.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2014125297/11.
(140143141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2014.
Akira S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1250 Luxembourg, 125, avenue du Bois.
R.C.S. Luxembourg B 176.055.
Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Soak Trust S.A.
Signature
Référence de publication: 2014125299/12.
(140142557) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2014.
Acquatica S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 39.729.
Société anonyme constituée suivant acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, notaire alors de résidence à Dudelange, en
date du 04 mars 1992, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 354 du 20 août 1992 et
dont les statuts ont été modifiés la dernière fois suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence
à Junglinster, en date du 9 décembre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 344
du 6 février 2014
Les comptes annuels de la société au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014125285/15.
(140143215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2014.
AEW Value Investors Asia II Feeder, L.P., Société en Commandite spéciale.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 180.330.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé gérant-commandité en date du 31 juillet 2014i>
Il résulte des décisions prises par l'associé gérant-commandité en date du 31 juillet 2014 que:
le siège social de la société a été transféré du 2, rue des Dahlias, L- 1411 Luxembourg au 24, rue Beaumont, L- 1219
Luxembourg et ce avec effet au 1
er
août 2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 août 2014.
Langham Hall Luxembourg Sàrl
Signature
<i>Agent domiciliatairei>
Référence de publication: 2014125289/16.
(140143423) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2014.
133771
L
U X E M B O U R G
Icomi Investissement S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 15, boulevard Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 65.406.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2014124361/10.
(140137871) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
août 2014.
IKAV General Partner S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 2, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 163.916.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 31 juillet 2014.
Référence de publication: 2014124364/10.
(140138584) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
août 2014.
PepsiCo Investments Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 150.391.
Le Bilan consolidé au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
(conforme Art. 314 du loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 août 2014.
Paul Galliver
<i>Gérant Bi>
Référence de publication: 2014125848/13.
(140142794) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2014.
New Luxis S.A., Société Anonyme,
(anc. WD Luxis S.C.A.).
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 117.662.
<i>Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue au siège social en date du 11 Juillet 2014i>
L'Assemblée Générale a décidé de reconduire les mandats des administrateurs suivants:
- Madame Simone Retter, avocate, avec adresse professionnelle au 14, Avenue du X Septembre, L- 2550 Luxembourg,
administrateur;
- Monsieur Guy Harles, avocat, avec adresse professionnelle au 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg, administrateur;
- Monsieur Roland Medawar, administrateur de sociétés, résidant au 138, rue Albert Unden, L-2652 Luxembourg,
administrateur et Président du Conseil d'Administration
Et du Commissaire aux Comptes:
FIN-Contrôle S.A., établie et ayant son siège social au 12, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, inscrite auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 42.230;
jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle des Actionnaires appelée à statuer sur l'exercice social clos au 31
décembre 2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 Août 2014.
Référence de publication: 2014125811/21.
(140142862) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2014.
133772
L
U X E M B O U R G
Smitham Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 141.847.
Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 December 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 août 2014.
Smitham Holding S.à r.l.
Johannes de Zwart
<i>Géranti>
Référence de publication: 2014125977/14.
(140143003) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2014.
Starpoint Holdings (Lux) BRL S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.
R.C.S. Luxembourg B 170.550.
Par résolutions signées en date du 6 août 2014, l'associé unique a décidé
- de nommer Julien Petitfrère, avec adresse professionnelle au 3 rue Mozart, L-2166 Luxembourg au mandat de gérant,
avec effet au 6 août 2014, et pour une durée indéterminée.
- de nommer Carl Tash, avec adresse professionnelle au 591 West Putnam Avenue, CT 06830 Greenwich, USA au
mandat de gérant, avec effet au 6 août 2014, et pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 août 2014.
Référence de publication: 2014125953/15.
(140143112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2014.
SHCO 83 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 188.419.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 1 i>
<i>eri>
<i> août 2014i>
En date du 1
er
août 2014, l'associé unique de la Société a décidé comme suit:
- d'accepter la démission d'Intertrust Management (Luxembourg) S.à r.l., de son mandat de gérant de la Société et ce
avec effet immédiat.
- de nommer Monsieur Seth KALVERT, né le 18 septembre 1969 à New York, Etats-Unis d'Amérique, demeurant au
141, Needham Street, Newton, MA 02464, Etats-Unis d'Amérique, en tant que gérant A de la Société pour une durée
indéterminée, et ce avec effet immédiat.
- de nommer Madame Elizabeth TIMMER, née le 24 juillet 1965 à Zuidelijke Ijsselmeerpolder, Pays-Bas, demeurant
professionnellement au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, en tant que gérant B de la Société pour une durée
indéterminée, et ce avec effet immédiat.
Le conseil de gérance de la Société se compose désormais comme suit:
- Seth KALVERT, gérant A
- Elizabeth TIMMER, gérant B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 août 2014.
Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2014125966/25.
(140142684) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2014.
133773
L
U X E M B O U R G
Immo Pasha S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2551 Luxembourg, 5, avenue du X Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 71.889.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014124366/10.
(140138010) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
août 2014.
Initiative S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 8, rue Philippe II.
R.C.S. Luxembourg B 170.556.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 31/07/2014.
Référence de publication: 2014124378/10.
(140138634) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
août 2014.
Alfa 2011 S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.
R.C.S. Luxembourg B 161.527.
Les bilan, compte pertes et profits et annexes au 31 décembre 2013, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 août 2014.
<i>Pour la Sociétéi>
Référence de publication: 2014124518/12.
(140141875) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2014.
Steyn Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 31.697.
<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration tenue en date du 20 mai 2014.i>
Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 20 mai 2014 que:
- Le siège social de la société est transféré du 42-44, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg au 50, rue Charles Martel,
L-2134 Luxembourg et ce, avec effet au 1
er
juin 2014.
- Les administrateurs M. Claude ZIMMER, M. Hendrik H.J. KEMMERLING et M. Rob SONNENSCHEIN sont domiciliés
professionnellement au 50, rue Charles Martel, 1
er
étage L-2134 Luxembourg et ce, avec effet au 1
er
juin 2014.
- L'administrateur LuxGlobal Management S.à r.l, société enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
Luxembourg sous le numéro B159.893 est transféré au 50, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg et ce, avec effet au
1
er
juin 2014. Représentant permanent M. Hendrik H.J. KEMMERLING domicilié professionnellement au 50, rue Charles
Martel, 1
er
étage L-2134 Luxembourg et ce, avec effet au 1
er
juin 2014.
- De nommer comme Président du Conseil d'Administration Monsieur Claude ZIMMER, Président et administrateur,
né le 18 juillet 1956 à Luxembourg (Luxembourg), domicilié professionnellement 50, rue Charles Martel 1
er
étage, L-2134
Luxembourg.
Extrait sincère et conforme
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2014125994/22.
(140142591) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2014.
133774
L
U X E M B O U R G
Les Servantes du Seigneur et de la Vierge de Matará asbl, Association sans but lucratif.
Siège social: L-1152 Luxembourg, 10, rue Sainte Thérèse d'Avila.
R.C.S. Luxembourg F 9.763.
Le 02 août 2014, le conseil d'administration de l'Association a décidé de transférer le siège social de l'association du
L-3391 Peppange, 3, rue Saint-Benoît au L-1152 Luxembourg, 10 rue Sainte Thérèse D'Avila.
En conséquence l'article 1.2 des statuts de l'Association sera désormais rédigé de la façon suivante:
1.2. Elle a son siège social à Luxembourg. Le siège social peut être transféré par simple décision du Conseil d'Admi-
nistration dans toute autre localité au Grand-Duché de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 06 août 2014.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2014125707/15.
(140142475) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2014.
Ave Este Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 136.210.
<i>Extrait des décisions prises par le conseil de gérance en date du 28 juillet 2014i>
Le siège a été transféré de L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, à L-2453 Luxembourg, 6,
rue Eugène Ruppert.
Veuillez noter que l'adresse professionnelle de Mme Valérie PECHON et de M. Emanuele GRIPPO, gérants B, se situe
désormais au L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
Luxembourg, le 5 août 2014.
Pour extrait et avis sincères et conformes
<i>Pour Ave Este Luxembourg S.àr.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.
Référence de publication: 2014124496/16.
(140141790) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2014.
SONAFI Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 29.901.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 21 juillet 2014i>
L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de:
- Monsieur Gilles JACQUET, employé privé, avec adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg;
- Monsieur Pieter VAN NUGTEREN, employé privé, avec adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163
Luxembourg;
- Lux Business Management S.à.r.l., employé privé, avec adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Lu-
xembourg, dont le représentant permanent est Monsieur Christian KNAUFF, avec adresse professionnelle 40, avenue
Monterey à L-2163 Luxembourg.
Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2014.
L'Assemblée renouvelle également le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant son siège
social 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg. Ce mandat prendra fin lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes
de l’exercice 2014.
Luxembourg, le 21 juillet 2014.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2014125988/23.
(140142758) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2014.
133775
L
U X E M B O U R G
INM Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 124.882.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014124379/9.
(140138663) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
août 2014.
Baek-Immo Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 122.279.
Les comptes consolidés au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
À Luxembourg, le 5 août 2014.
Référence de publication: 2014124551/11.
(140141631) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2014.
BR Gaming Development S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3670 Kayl, 208, rue de Noertzange.
R.C.S. Luxembourg B 168.397.
EXTRAIT
En date du 11 juillet 2014, M. Julien Leleu a démissionné de sa fonction de délégué à la gestion journalière de la Société
avec effet immédiat et M. Patrick Bosch a démissionné de sa fonction de directeur général avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 août 2014.
Référence de publication: 2014127699/12.
(140144480) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2014.
BR Gaming Development S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3670 Kayl, 208, rue de Noertzange.
R.C.S. Luxembourg B 168.397.
<i>Extrait des résolutions des actionnaires à Luxembourg le 11 juillet 2014i>
Nomination des nouveaux Administrateurs:
- Madame Raquel SHELDON, née le 13 novembre 1970 à Caracas (Venezuela), demeurant professionnellement au 50,
7
th
Street, Houghton Estate, Johannesburg 2198, South Africa;
- M. Graham BRUCE, né le 05 septembre 1967 à Redruth (Royaume-Uni), demeurant professionnellement au 50, 7
th
Street, Houghton Estate, Johannesburg 2198, South Africa;
- Madame Louise PALMER, née le 25 décembre 1968 à Welwyn Garden City (Royaume-Uni), demeurant profession-
nellement au Montevideo Hills, C5, Calle Priorata - 15, Atalay-Parque Antena, Estepona 29680, Malaga (Espagne);
- M. Andrew BEHAN né le 15 septembre 1966 à Burton Upon Trent (Royaume-Uni), demeurant professionnellement
au Montevideo Hills, C5, Calle Priorata - 15, Atalay-Parque Antena, Estepona 29680, Malaga (Espagne).
Les Administrateurs sont nommés pour une durée de six ans.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juillet 2014.
<i>Pour BR Gaming Development S.A.
Les actionnairesi>
Référence de publication: 2014127700/22.
(140145144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2014.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
133776
Accharius Invest S.A.
Acquatica S.A.
AEW Value Investors Asia II Feeder, L.P.
AGR Europe S.à r.l.
Airtime Projects
Akira S.à r.l.
Alfa 2011 S.A., SPF
ALTAIRA Funds
Ave Este Luxembourg S.à r.l.
Baek-Immo Sicav
Basic Holding S.A.
Borrow Investment S.A.
BR Gaming Development S.A.
BR Gaming Development S.A.
b-to-v Private Equity S.C.S., SICAR
Cana S.C.I.
eBay International AG (Luxembourg branch)
Garmin Luxembourg S.à r.l.
Hakon S.A.
Hayfin Capital LuxCo 2
HBM BioCapital II Invest
Hefeng Holding
HIB, Holding Invest Batiment S.A.
Hôtel Europe S.à r.l.
Hotel Group Maas
ICI Invest S.A.
Icomi Investissement S.A. SPF
IKAV General Partner S.à r.l.
Immo Pasha S.à r.l.
Initiative S.A.
INM Luxembourg S.à r.l.
international quiding S.à r.l.
Interportfolio II
I-Real S.à.r.l.
Jewel HoldCo S.à r.l.
JP Advice S.A.
Koch Chemical Technology LP1 S.à r.l.
Les Servantes du Seigneur et de la Vierge de Matará asbl
LuxPol Invest S.à r.l.
Mandatum Life Fund Management S.A.
Mandatum Life Sicav-Sif
Mikassa S.A.
NB Global Floating Rate Income Fund (Lux) 1 S.à r.l.
New Luxis S.A.
Ojai Holding S.A.
PepsiCo Investments Luxembourg S.à r.l.
Roma Investments
S+B Inbau S.à r.l.
SHCO 83 S.à r.l.
Smitham Holding S.à r.l.
SONAFI Spf S.A.
Starpoint Holdings (Lux) BRL S.à r.l.
Steyn Holding S.A.
Ticketmaster Luxembourg Holdco 2, S.à r.l.
Utah JV S.à r.l.
VR Netze Luxemburg S.à r.l.
WD Luxis S.C.A.