This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2677
2 octobre 2014
SOMMAIRE
21st Century Soccer S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
128453
Argon Investment S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
128463
Avolon Holding Corporation (Luxem-
bourg) III S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128459
C5 Partners S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128458
C7 Massylux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128495
Chelsea Wharf Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . .
128460
Chronotron S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128460
Eggon S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128458
EuroInformation International . . . . . . . . . .
128450
Even RX Zehn S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128451
Even RX Zwölf S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128451
Ever Capital S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128450
Ever Capital S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128450
Ever Capital S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128450
Falconer II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128453
Falconer II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128453
FGL Lux Holdings, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
128475
Fiduciaire Claude Uhres et Cie S.A. . . . . .
128453
Fiduciaire Luxembourg Paris Genève S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128450
Fiduciaire Principale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128454
Fiducis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128454
Filvest Management S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
128460
Fimaco International S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
128451
Fior Ateliers S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128475
Fitlosophy S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128452
FM Investment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128453
Fondation AGGL - FNEL . . . . . . . . . . . . . . .
128478
Freepost S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128450
FRM Participations S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
128454
FundTap S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128452
Galapagos LuxCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
128461
Galeria K S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128455
GEVAPAN INVEST Spf S.A. . . . . . . . . . . . .
128494
Global Indemnity (Luxembourg) S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128462
GMT Bigstar S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128451
Greening Partners International S.àr.l. . . .
128452
GWA SIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128452
Harmonie Cuisines S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
128460
Hasenkamp Luxemburg S.à r.l. . . . . . . . . . .
128461
Heco S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128462
Heinz Finance (Luxembourg) S.à r.l. . . . . .
128454
Helis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128462
H.I.G. Luxembourg Holdings 48 S.à r.l. . . .
128458
HSBC Equities (Luxembourg) S.à r.l. . . . .
128452
IMAGE3G S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128461
Mangrove IV (SCA), SICAR . . . . . . . . . . . . .
128481
Pro Energies S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128496
Randstad Group Luxembourg S.à r.l. . . . .
128451
Real Estate Property 7 S.A. . . . . . . . . . . . . .
128455
Robelco International Real Estate Deve-
lopments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128455
Robien S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128457
Saddle Luxco Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
128457
Scala International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
128459
SDA International S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
128471
Sernami Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128457
Silver Star Investment S.à r.l. . . . . . . . . . . .
128459
Société d'investissement Afrique Méditer-
ranée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128454
Staco International SA . . . . . . . . . . . . . . . . .
128463
Sunny Seasons S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128456
Villa Lago Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
128456
Way LuxCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128456
128449
L
U X E M B O U R G
EuroInformation International, Société Anonyme.
Siège social: L-2529 Howald, 55, rue des Scillas.
R.C.S. Luxembourg B 162.712.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014109327/9.
(140130717) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2014.
Ever Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 136.262.
Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014109371/9.
(140131469) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2014.
Ever Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 136.262.
Le bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014109373/9.
(140131471) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2014.
Ever Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 136.262.
Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014109372/9.
(140131470) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2014.
Freepost S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 55, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 113.017.
Les comptes au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014109386/9.
(140130863) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2014.
Fiduciaire Luxembourg Paris Genève S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1651 Luxembourg, 15-17, avenue Guillaume.
R.C.S. Luxembourg B 84.426.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014109380/9.
(140131506) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2014.
128450
L
U X E M B O U R G
Fimaco International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5627 Mondorf-les-Bains, 13, avenue Lou Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 99.767.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014109400/9.
(140130620) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2014.
Even RX Zehn S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1460 Luxembourg, 48, rue d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 163.313.
Les comptes annuels au 30 septembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2014109369/10.
(140131225) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2014.
Even RX Zwölf S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1460 Luxembourg, 48, rue d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 176.348.
Les comptes annuels au 30 septembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2014109370/10.
(140131223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2014.
GMT Bigstar S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 100.000,00.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 161.100.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour GMT Bigstar S.à r.l.
Mandatairei>
Référence de publication: 2014109451/11.
(140131487) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2014.
Randstad Group Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 138.754.
Afin de bénéficier de l'exemption de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion,
prévue par l'article 314 de la loi sur les sociétés commerciales, les comptes consolidés au 31 décembre 2012 de sa société
mère, RANDSTAD ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juillet 2014.
Référence de publication: 2014110904/12.
(140131815) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2014.
128451
L
U X E M B O U R G
Fitlosophy S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7240 Bereldange, 87, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 154.913.
Le bilan au 31.12.2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 juillet 2014.
Référence de publication: 2014109383/10.
(140131463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2014.
FundTap S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2611 Luxembourg, 51, route de Thionville.
R.C.S. Luxembourg B 145.603.
Les comptes annuels au 31/12/2013 de la société FundTap S.àr.l., Société à responsabilité limitée, ont été déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014109389/10.
(140130496) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2014.
Greening Partners International S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 13.000,00.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 44, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 68.303.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juillet 2014.
<i>Pour GREENING PARTNERS INTERNATIONAL S. à R.L.i>
Référence de publication: 2014109458/11.
(140130938) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2014.
GWA SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 157.845.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour GWA SIF
i>Caceis Bank Luxembourg
Référence de publication: 2014109464/11.
(140130782) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2014.
HSBC Equities (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 16, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 168.157.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour HSBC Equities (Luxembourg) S.à r.l.
i>HSBC Securities Services (Luxembourg) S.A.
Signatures
Référence de publication: 2014110544/12.
(140132135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2014.
128452
L
U X E M B O U R G
Falconer II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 147.530.
Le bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014109392/9.
(140131496) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2014.
Falconer II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 147.530.
Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014109391/9.
(140131495) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2014.
Fiduciaire Claude Uhres et Cie S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1832 Luxembourg, 10, rue Jean Jacoby.
R.C.S. Luxembourg B 51.515.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juillet 2014.
Signature.
Référence de publication: 2014109396/10.
(140131455) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2014.
FM Investment, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 12, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 166.112.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Sociétéi>
Référence de publication: 2014109411/10.
(140131602) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2014.
21st Century Soccer S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 100.000,00.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 187.983.
EXTRAIT
Suivant un contrat de transfert de parts sociales en date du 11 juillet 2014, 3.750 parts sociales émises par la Société
et détenues par Monsieur Lucio Di Geronimo, né le 6 janvier 1970 à Leonberg, Allemagne, ayant son adresse à Esmarchstr.
21a, D-80999 Munich, Allemagne, ont été transférées à Madame Manuela Niggl, née le 29 octobre 1963 à Landau in der
Pfalz, Allemagne, ayant son adresse à Am Weiher 6, D-83043 Bad Aibling, Allemagne.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juillet 2014.
<i>Pour 21 i>
<i>sti>
<i> Century Soccer S.à r.l.i>
Référence de publication: 2014115776/16.
(140135275) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2014.
128453
L
U X E M B O U R G
Fiduciaire Principale, Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 15, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 57.661.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014109397/9.
(140130395) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2014.
Fiducis, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 12, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 113.938.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014109398/9.
(140130672) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2014.
FRM Participations S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R.C.S. Luxembourg B 58.158.
Les comptes annuels au 28/02/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014109419/10.
(140131351) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2014.
Heinz Finance (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 415.386.399,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 149.974.
Les comptes pour la période du 29 avril 2013 au 29 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juillet 2014.
Référence de publication: 2014109477/11.
(140131398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2014.
SIAM, Société d'investissement Afrique Méditerranée, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.
R.C.S. Luxembourg B 169.084.
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal des décisions adoptées par les associés de la société en date du 25 juillet 2014i>
Il résulte dudit procès-verbal que Monsieur Gabriel JEAN, domicilié professionnellement au 10B rue des Mérovingiens,
L-8070 Bertrange a été nommé au poste de gérant et de Président à partir de ce jour pour une durée indéterminée.
Le poste de gérance se décompose donc de la manière suivante:
- Monsieur Amir BEN YAHMED demeurant 10 rue Paul Baudry, F-75008 Paris (France)
- Monsieur Marwane BEN YAHMED demeurant 23 rue Edimbourg, F-75008 Paris (France)
- Monsieur Gabriel JEAN, 10B rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange
<i>Pour Société d'Investissement Afrique Méditerranéei>
Référence de publication: 2014110964/15.
(140132379) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2014.
128454
L
U X E M B O U R G
Galeria K S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.516,00.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 157.007.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2014109423/10.
(140130502) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2014.
Real Estate Property 7 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 175.513.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 23 juillet 2014i>
Est nommé administrateur, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2020:
- Monsieur Simon Pierre SAVERYS, demeurant professionnellement au 18, rue Robert Stümper, L - 2557 Luxembourg;
- Madame Maïthé DAUPHIN, demeurant professionnellement au 18, rue Robert Stümper, L - 2557 Luxembourg;
- Monsieur Laurent WEIS, demeurant au 18, rue Robert Stümper, L - 2557 Luxembourg;
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en
2020:
- Audit Lux S.à r.l., 18, rue Robert Stümper L-2557 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014115513/16.
(140134736) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2014.
RIRED S.A., Robelco International Real Estate Developments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 132.442.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 30 août 2013i>
<i>Conseil d'administrationi>
Le mandat de trois administrateurs était à expiration après l'assemblée générale du 30 août 2013. Les mandats suivants
ont été renouvelés:
- BELFILUX SA, ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 9b boulevard du Prince Henri,
- Fons MANGEN, expert comptable, demeurant à L-9088 Ettelbruck, rue de Warken 147.
BELFILUX SA a été nommé en tant qu'administrateur délégué.
Suite à ces décisions le conseil d'administration en fonction se compose comme suite:
BELFILUX SA, 9b boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, administrateur délégué jusqu'à l'assemblée générale
de 2018;
MANGEN Fons, réviseur d'entreprises, 147 rue de Warken à L-9088 Ettelbruck, administrateur; jusqu'à l'assemblée
générale de 2018;
JOSTI NV, Avenue du Port 86C bte 103 à B- 1000 Bruxelles, administrateur A jusqu'à l'assemblée qui se tiendra en
2018.
<i>Commissaire aux comptesi>
L'assemblée générale a renouvelé le mandat du commissaire aux comptes. Suite à cette décision le commissaire aux
comptes en fonction jusqu'à l'assemblée générale de 2018 est COMODORO FINANCE SA, 9b boulevard du Prince
Henri, L-1724 Luxembourg.
BELFILUX SA
Signature
<i>Un administrateuri>
Référence de publication: 2014110932/28.
(140131894) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2014.
128455
L
U X E M B O U R G
Sunny Seasons S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6630 Wasserbillig, 40-42, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 124.332.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014110015/10.
(140131402) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2014.
Villa Lago Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4940 Bascharage, 111-115, avenue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 103.870.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 26 juin 2014i>
L'Assemblée Générale a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
De renouveler le mandat des administrateurs actuels Monsieur Philippe VANDERHOVEN, Monsieur Jean-Yves STAS-
SER et la société CEPACOS INVESTMENTS S.A., société anonyme, représentée par Monsieur Philippe VANDERHOVEN,
représentant permanent. Leur mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale annuelle de 2020.
Pour extrait conforme
Le 23/07/2014.
Référence de publication: 2014110087/14.
(140130698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2014.
Way LuxCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,04.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 151.888.
EXTRAIT
Les associés de la Société, par résolutions écrites datées du 24 juin 2014 et avec effet immédiat, ont décidé:
1 d'accepter la démission des personnes suivantes:
- Monsieur Lars Frankfelt, gérant de catégorie B
- Monsieur Mats Eklund, gérant de catégorie A
- Monsieur Antonis Tzanetis, gérant de catégorie A
2 de nommer les personnes suivantes en tant que gérants de la Société pour une période indéfinie:
- Monsieur Thomas Sonnenberg, demeurant professionnellement 26-28 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, en
tant que gérant de catégorie A
- Monsieur Mukul Sharma, demeurant professionnellement 32 Woodhouse Eaves, Middlesex, Northwood, HA6 3NF,
en tant que gérant de catégorie B
- Monsieur Matthew Orili, demeurant professionnellement Autumn Flower, Clos Cerise, La Grande Route de St Martin,
St Saviour, Jersey, JE2 7GT, en tant que gérant de catégorie B
3 de modifier la classification de Monsieur Michiel Kramer agissant actuellement en sa capacité de gérant de catégorie
B de la Société et de le qualifier en tant que gérant de catégorie A de la Société
Dès lors, le conseil de gérance de la Société est composé de la manière suivante:
Monsieur Michiel Kramer, gérant de catégorie A
Monsieur Mukul Sharma, gérant de catégorie B
Monsieur Thomas Sonnenberg, gérant de catégorie A
Monsieur Matthew Crill, gérant de catégorie B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Way LuxCo S.à r.l.i>
Référence de publication: 2014110092/30.
(140131154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2014.
128456
L
U X E M B O U R G
Robien S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 86.718.
Les comptes annuels, les comptes de Profits et Pertes ainsi que les Annexes de l'exercice clôturant au 31/12/2013 ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>L'Organe de Gestioni>
Référence de publication: 2014110934/11.
(140132364) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2014.
Sernami Invest S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.
R.C.S. Luxembourg B 145.907.
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal des décisions adoptées à Luxembourg le 19 mai 2014i>
Il résulte dudit procès-verbal que le mandat d'administrateur de Monsieur Marc SCHMIT, demeurant professionnel-
lement au 231 Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg a été renouvelé pour une période de 6 ans. Son mandat viendra
à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2020.
Il résulte également dudit procès-verbal que le mandat de commissaire aux comptes de la société MARBLEDEAL
Luxembourg Sàrl, avec siège social au 10B rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange a été renouvelé pour une période de
6 ans. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2020.
<i>Pour SERNAMI INVEST S.A.i>
Référence de publication: 2014110979/15.
(140131819) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2014.
Saddle Luxco Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 185.017.
EXTRAIT
Les associés de la Société, par résolutions écrites datées du 24 juin 2014 et avec effet immédiat, ont décidé:
1 d'accepter la démission des personnes suivantes:
- Monsieur Lars Frankfelt, gérant de catégorie A
- Monsieur Mats Eklund, gérant de catégorie B
- Monsieur Antonis Tzanetis, gérant de catégorie B
2 de nommer les personnes suivantes en tant que gérants de la Société pour une période indéfinie:
- Monsieur Thomas Sonnenberg, demeurant professionnellement 26-28 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, en
tant que gérant de catégorie A
- Monsieur Mukul Sharma, demeurant professionnellement 32 Woodhouse Eaves, Middlesex, Northwood, HA6 3NF,
en tant que gérant de catégorie B
Monsieur Matthew Grill, demeurant professionnellement Autumn Flower, Clos Cerise, La Grande Route de St Martin,
St Saviour, Jersey, JE2 7GT, en tant que gérant de catégorie B
Dès lors, le conseil de gérance de la Société est composé de la manière suivante:
Monsieur Michiel Kramer, gérant de catégorie A
Monsieur Mukul Sharma, gérant de catégorie B
Monsieur Thomas Sonnenberg, gérant de catégorie A
Monsieur Matthew Grill, gérant de catégorie B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Saddle LuxCo Holding S.à r.l.i>
Référence de publication: 2014110943/28.
(140131855) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2014.
128457
L
U X E M B O U R G
C5 Partners S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 171.345.
Il est porté à la connaissance de tous que le siège social de la société a fait l'objet d'un changement à partir du 25 juillet
2014. A savoir:
Transfert au 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2014110356/13.
(140132619) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2014.
H.I.G. Luxembourg Holdings 48 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 188.854.
En date du 11 juillet 2014, l'associé unique H.I.G. Europe Capital Partners II, L.P., avec siège social au South Church
Street, Ugland House, George Town, Grand Cayman, Iles Caïmans, a cédé la totalité de ses 12 500 parts sociales à H.I.G.
Europe-Valdes Ltd, avec siège social au Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Îles Caïmans,
qui les acquiert.
En conséquence, l'associé unique de la société est le suivant:
- H.I.G. Europe-Valdes Ltd., précité, avec 12 500 parts sociales
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juillet 2014.
Référence de publication: 2014113414/16.
(140133211) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2014.
Eggon S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 155.971.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'AGE du 23 juillet 2014i>
l'Assemblée adopte à l'unanimité les résolutions suivantes:
Il est décidé de nommer les administrateurs suivants:
- Monsieur André Paul MILLER, né le 06/02/1966 à Raon-L'étape, France, professeur de physique, demeurant à F-54000
Nancy, 14 avenue Garenne, avec pouvoir de signature de catégorie A;
- Monsieur Gabriel BUGALA, né le 16/10/1966 à Woippy, France, ingénieur, demeurant à L-4361 Esch-sur-Alzette, 12
avenue du Rock 'n Roll avec pouvoir de signature de catégorie B;
- Monsieur Alain VASSEUR, né le 24/04/1958 à Dudelange, Luxembourg, consultant, demeurant à L-8277 Holzem 3
rue de Mamer avec pouvoir de signature de catégorie B;
4. Il est décidé de nommer le commissaire aux comptes suivant:
TRIPLE A CONSULTING S.A. avec siège social à L-2156 Luxembourg 2 rue Millegässel, no RCS B61 417.
5. Il est décidé de transférer le siège à l'adresse suivante:
3, Place F-J Dargent L-1413 Luxembourg
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale
Statutaire de 2020.
Luxembourg, le 23/07/2014.
Certifié sincère et conforme
Triple A Consulting S.A.
Référence de publication: 2014117203/25.
(140135445) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2014.
128458
L
U X E M B O U R G
Avolon Holding Corporation (Luxembourg) III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 157.858.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions de l'associé unique de la Société prises en date du 28 juillet 2014 que:
- la démission de Monsieur Benoit Bauduin, gérant de classe B de la Société a été acceptée avec effet immédiat;
- Monsieur Livio Gambardella, né le 2 décembre 1975 à Terlizzi (Italie) résidant professionnellement au 16, avenue
Pasteur L-2310 Luxembourg a été nommée gérant de classe B de la société avec effet immédiat et ce pour une durée
indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 29 juillet 2014.
Référence de publication: 2014117573/17.
(140135231) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2014.
Silver Star Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1318 Luxembourg, 58, rue des Celtes.
R.C.S. Luxembourg B 171.152.
<i>Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 28 juillet 2014i>
Il résulte des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société à responsabilité
limitée SILVER STAR INVESTMENT S.A.R.L. (B171152), avec siège social à L-1318 Luxembourg, 58, rue des Celtes, en
date du 28 juillet 2014:
La révocation en date du 28 juillet 2014 de Madame Catherine Guidarelli, demeurant à F-57950 Montigny-les-Metz,
213, rue du Pont-à-Mousson, de sa fonction de gérant.
La nomination en date du 28 juillet 2014 de Madame Sabrina Brik, demeurant à F-57000 Neufchef, 34, rue du Conroy,
au poste de gérant
La société est valablement engagée par la seule et unique signature du gérant.
Pour extrait conforme
Fait à Luxembourg, au siège social de la société, le 28 juillet 2014.
Référence de publication: 2014115593/18.
(140134508) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2014.
Scala International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 19.121.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 21 juillet 2014i>
1. Les administrateurs ainsi que le commissaire sortant sont réélus jusqu'à l'assemblée générale qui aura lieu en 2019.
<i>Administrateurs:i>
- Monsieur Claude Schroeder, demeurant au 498, route de Thionville, L-5886 Alzingen. Monsieur Dominique Fontaine,
demeurant au 78, rue du Castel, B-6700 Arlon.
<i>Commissaire:i>
- Stratego International Sàrl, avec son siège social au 370, route de Longwy L-1940 Luxembourg.
2. Monsieur Pierre Goffinet, demeurant professionnellement au 370, route de Longwy L-1940 Luxembourg a été
nommé administrateur jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2016 en remplacement de Monsieur Herbert
Grossmann décédé le 17 juin 2014.
Pour extrait conforme
D. FONTAINE
Référence de publication: 2014118857/19.
(140137068) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2014.
128459
L
U X E M B O U R G
Filvest Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 10-12, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 150.504.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014109399/9.
(140130666) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2014.
Harmonie Cuisines S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8210 Mamer, 102, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 160.046.
En date du 09/07/2014, l'assemblé prend la décision de nommer Monsieur Christophe Didier, demeurant à Niederkorn,
54a, rue Franz Erpelding comme administrateur jusqu'à l'assemblée générale de 2017.
Monsieur Koch
<i>Le Présidenti>
Référence de publication: 2014109491/11.
(140130693) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2014.
Chronotron S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 55, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 115.720.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique de la société prise à Luxembourg en date du 26 juin 2014i>
L'associé unique a pris la résolution suivante:
- Madame Sandra CALVARUSO est révoquée avec date d'effet au 26 juin 2014 de son mandat de gérante pour lequel
elle avait été nommée avec date d'effet au 1
er
août 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Samuel HAAS.
Référence de publication: 2014113140/14.
(140133928) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2014.
Chelsea Wharf Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 581.574,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 170.759.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique en date du 24 juillet 2014i>
En date du 24 juillet 2014, l'associé unique a décidé comme suit:
- D'accepter la nomination de Monsieur Jérôme Philippe LETSCHER, né le 21 mai 1973 à Luxembourg, ayant son
adresse professionnelle au 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, en qualité de gérant de la Société avec effet
immédiat et pour une durée indéterminée.
- D'accepter la nomination de Monsieur Charles Harvie LE CORNU, né le 10 février 1981 à Jersey, ayant son adresse
professionnelle au Ogier House, The Esplanade, St Helier JE4 9WG, Jersey, en qualité de gérant de la Société avec effet
immédiat et pour une durée indéterminée.
Luxembourg, le 25 juillet 2014.
Pour extrait analytique conforme
Michel Thill
<i>Géranti>
Référence de publication: 2014113139/20.
(140133388) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2014.
128460
L
U X E M B O U R G
IMAGE3G S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8385 Koerich, 1, rue du Château.
R.C.S. Luxembourg B 162.693.
Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
IMAGE3G S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Référence de publication: 2014109522/13.
(140130746) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2014.
Hasenkamp Luxemburg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1360 Findel, Luxair Cargo Center.
R.C.S. Luxembourg B 115.850.
Laut Beschluss der Ordentlichen Gesellschafterversammlung vom 30. Juni 2014 wurde die Gesellschaft ABACAB S.àr.l.
mit Gesellschaftssitz in 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg, eingetragen im Handelsregister R.C.S. Luxem-
bourg unter der Nummer B 50.797, zum Aufsichtskommissar für die Prüfung des Jahresabschlusses des Geschäftsjahres
2014 ernannt.
Für gleichlautenden Auszug
SG AUDIT S.àr.l.
Référence de publication: 2014109474/13.
(140131049) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2014.
Galapagos LuxCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 186.260.
EXTRAIT
Les associés de la Société, par résolutions écrites datées du 24 juin 2014 et avec effet immédiat, ont décidé:
1 d'accepter la démission des personnes suivantes:
- Monsieur Lars Frankfelt, gérant de catégorie A
- Monsieur Mats Eklund, gérant de catégorie B
- Monsieur Antonis Tzanetis, gérant de catégorie B
2 de nommer les personnes suivantes en tant que gérants de la Société pour une période indéfinie:
- Monsieur Thomas Sonnenberg, demeurant professionnellement 26-28 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, en
tant que gérant de catégorie A
- Monsieur Mukul Sharma, demeurant professionnellement 32 Woodhouse Eaves, Middlesex, Northwood, HA6 3NF,
en tant que gérant de catégorie B
- Monsieur Matthew Crill, demeurant professionnellement Autumn Flower, Clos Cerise, La Grande Route de St Martin,
St Saviour, Jersey, JE2 7GT, en tant que gérant de catégorie B
Dès lors, le conseil de gérance de la Société est composé de la manière suivante:
Monsieur Michiel Kramer, gérant de catégorie A
Monsieur Mukul Sharma, gérant de catégorie B
Monsieur Thomas Sonnenberg, gérant de catégorie A
Monsieur Matthew Crill, gérant de catégorie B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Galapagos LuxCo S.à r.l.i>
Référence de publication: 2014109422/28.
(140131442) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2014.
128461
L
U X E M B O U R G
Global Indemnity (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1253 Luxembourg, 2A, rue Nicolas Bové.
R.C.S. Luxembourg B 152.752.
<i>Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 30 juillet 2014i>
1. Monsieur Pietro LONGO a démissionné de son mandat de gérant.
2. Monsieur Jérôme DEVILLET, administrateur de sociétés, né le 21 mai 1986 à Arlon (Belgique), demeurant profes-
sionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommé comme gérant pour une durée indéterminée.
Veuillez prendre note que l'adresse professionnelle de Monsieur Pierre CLAUDEL se trouve dorénavant à L-2453
Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
Luxembourg, le 30.7.2014.
Pour extrait et avis sincères et conformes
<i>Pour Global Indemnity (Luxembourg) S.àr.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.
Référence de publication: 2014117275/17.
(140135461) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2014.
Helis, Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 1, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 120.389.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale du 8 juillet 2014i>
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont prolongés jusqu'à l'assemblée générale ordinaire
qui se tiendra en 2015.
<i>Administrateursi>
Thomas OBERWEIS, maître boulanger-pâtissier, 9 rue Neuhaeusgen, L-5368 Schuttrange
Pierre OBERWEIS, maître boulanger-pâtissier, 51 rue Kohlenberg, L-1870 Luxembourg
Joseph OBERWEIS, maître boulanger-pâtissier, 28 route de Wormeldange, L-6955 Rodenbourg
<i>Commissaire aux comptesi>
Paul LAPLUME, expert-comptable, 42 rue des Cerises, L - 6113 Junglinster
Pour extrait conforme
Paul LAPLUME
Référence de publication: 2014113444/18.
(140133142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2014.
Heco S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 14.566.
<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration tenue en date du 19 mai 2014.i>
Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 19 mai 2014 que:
- Le siège social de la société est transféré du 42-44, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg au 50, rue Charles Martel,
L-2134 Luxembourg et ce, avec effet au 1
er
juin 2014.
- Les administrateurs M. Claude ZIMMER, M. Hendrik H.J. KEMMERLING et M. Rob SONNENSCHEIN sont domiciliés
professionnellement au 50, rue Charles Martel, 1
er
étage L-2134 Luxembourg et ce, avec effet au 1
er
juin 2014.
- L'administrateur LuxGlobal Management S.à r.l, société enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
Luxembourg sous le numéro B159.893 est transféré au 50, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg et ce, avec effet au
1
er
juin 2014. Représentant permanent M. Hendrik H.J. KEMMERLING domicilié professionnellement au 50, rue Charles
Martel, 1
er
étage L-2134 Luxembourg et ce, avec effet au 1
er
juin 2014.
Extrait sincère et conforme
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2014113442/19.
(140133344) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2014.
128462
L
U X E M B O U R G
Staco International SA, Société Anonyme.
Siège social: L-2562 Luxembourg, 4, place de Strasbourg.
R.C.S. Luxembourg B 84.325.
Les statuts coordonnés de la prédite société au 09 juillet 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Beringen, le 25 juillet 2014.
Maître Marc LECUIT
<i>Notairei>
Référence de publication: 2014111013/13.
(140132142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2014.
Argon Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 188.884.
STATUTES
In the year two thousand and fourteen, on the seventeenth day of the month of July.
Before Maître Cosita Delvaux, notary, residing in Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
BRE/Europe 7Q S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited liability company) incorporated under the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, having
a share capital of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500) and being registered with the Registre de Commerce
et des Sociétés in Luxembourg under number B 180.323,
represented by Mr Patrick Santer, master at laws, professionally residing in Luxembourg pursuant to a proxy dated
on 17 July 2014, which shall be registered together with the present deed.
The appearing party, acting in the above stated capacity, has requested the undersigned notary to draw up the articles
of incorporation of a limited liability company Argon Investment S.à r.l. (société à responsabilité limitée) which is hereby
established as follows:
Art. 1. Denomination. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name “Argon Investment
S.à r.l.” (the “Company”) is hereby formed by the appearing party and all persons who will become shareholders the-
reafter. The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.
Art. 2. Object. The object of the Company shall be the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg
and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and
development of its portfolio.
The Company may also carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of real estate,
properties and real estate rights in Luxembourg and abroad as well as any participations in any real estate enterprise or
undertaking in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those participa-
tions and assets.
The Company may further give guarantees, grant security interests, grant loans or otherwise assist the companies in
which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may also acquire loans including at a discount, originate loans and lend funds under any form, advance
money or give credit on any terms including without limitation resulting from any borrowings of the Company or from
the issue of any equity or debt securities of any kind to any person or entity as it deems fit in relation to any real estate
enterprise or undertaking. The Company may enter into swaps, futures, forwards, derivatives, options, repurchase, stock
lending and similar transactions, and, without prejudice to the generality of the foregoing, employ any techniques and
instruments in connection with its real estate activities. The Company may also enter into any guarantees, contracts of
indemnities, security interests and any other equivalent agreements in order to receive the benefit of any guarantee and/
or security interest granted in the context of such real estate activities. The Company may undertake any roles necessary
in connection with such lending activity including, without limitation, the role of arranger, lead manager, facility agent,
security agent, documentation agent. The Company shall not undertake such real estate lending or real estate loan
acquisition activities in a way that would require it to be regulated pursuant to the Luxembourg act dated 5 April 1993
on the financial sector, as amended or any future act or regulation amending or replacing such act.
128463
L
U X E M B O U R G
The Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or indirectly
in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purposes.
In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their admi-
nistration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other
advisors.
Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period.
Art. 4. Registered Office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an
extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles of
association.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the
case may be the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the manager, or as the case may be the board of managers, should determine that extraordinary
political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances;
such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified
to any interested parties by the manager or as the case may be the board of managers.
Art. 5. Share capital. The issued share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euros (EUR
12,500) represented by five hundred (500) shares with a nominal value of twenty-five Euros (EUR 25) each. The capital
of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for
amendment of these articles of association and the Company may proceed to the repurchase of its other shares upon
resolution of its shareholders.
Any available share premium shall be distributable.
Art. 6. Transfer of Shares. Shares are freely transferable among shareholders. Except if otherwise provided by law, the
share transfer to non-shareholders is subject to the consent of shareholders representing at least seventy-five per cent
(75%) of the Company's share capital.
Art. 7. Management of the Company. The Company is managed by one or several managers who do not need to be
shareholders.
The sole manager or as the case may be, the board of managers, is vested with the broadest powers to manage the
business of the Company and to authorise and/or perform all acts of disposal and administration falling within the purposes
of the Company. All powers not expressly reserved by the law or by the articles of association to the general meeting
shall be within the competence of the sole manager or as the case may be, the board of managers.
Vis-à-vis third parties the sole manager or as the case may be, the board of managers, has the most extensive powers
to act on behalf of the Company in all circumstances and to do, authorise and approve all acts and operations relative to
the Company and not reserved by law or these articles of association to the general meeting of shareholders.
The managers are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of share-
holders, which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed
for an undetermined period. The managers may be re-elected but their appointment may also be revoked with or without
cause (ad nutum) at any time.
In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. Any manager may participate in
any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the
persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also at
any time be held by conference call or similar means only. The participation in, or the holding of, a meeting by these
means is equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be
represented at meetings of the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager
may accept and vote.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours (24) at
least in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by cable, telegram, telex, e-mail or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening
notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted
by the board of managers.
Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company.
128464
L
U X E M B O U R G
The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman of that meeting or, in its absence,
by any two managers. Copies or excerpts of such minutes shall be signed by the chairman of that meeting or by any two
managers.
The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means
when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety
will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including circular
resolutions, may be conclusively certified or an extract thereof may be issued under the individual signature of any
manager.
The Company will be bound by the sole signature in the case of a sole manager, and in the case of a board of managers
by the sole signature of anyone of the managers. In any event the Company will be validly bound by the sole signature of
any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by the sole manager (if there is only
one) or as the case may be the board of managers or anyone of the managers.
Art. 8. Liability of the Managers. The manager(s) are not held personally liable for the indebtedness of the Company.
As agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties.
Subject to the exceptions and limitations listed below, every person who is, or has been, a manager or officer of the
Company shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against all
expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding which he becomes
involved as a party or otherwise by virtue of his being or having been such manager or officer and against amounts paid
or incurred by him in the settlement thereof. The words "claim", "action", "suit" or "proceeding" shall apply to all claims,
actions, suits or proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words "liability"
and "expenses" shall include without limitation attorneys' fees, costs, judgements, amounts paid in settlement and other
liabilities.
No indemnification shall be provided to any manager or officer:
(i) against any liability to the Company or its shareholders by reason of wilful misfeasance, bad faith, gross negligence
or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office;
(ii) with respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated to have acted in bad faith and not in
the interest of the Company; or
(iii) in the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of competent jurisdiction or by
the board of managers.
The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any manager
or officer may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such manager or officer
and shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein shall
affect any rights to indemnification to which corporate personnel, including directors and officers, may be entitled by
contract or otherwise under law.
Expenses in connection with the preparation and representation of a defence of any claim, action, suit or proceeding
of the character described in this article shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof upon receipt
of any undertaking by or on behalf of the officer or director, to repay such amount if it is ultimately determined that he
is not entitled to indemnification under this article.
Art. 9. Shareholder voting rights. Each shareholder may take part in collective decisions. He has a number of votes
equal to the number of shares he owns and may validly act at any meeting of shareholders through a special proxy.
Art. 10. Shareholder meetings. Decisions by shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as pre-
scribed by Luxembourg Company law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings. Any regularly constituted
meeting of shareholders of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the entire
body of shareholders of the Company.
Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to shareholders to their address appearing
in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire
share capital of the Company is represented at a meeting, the meeting may be held without prior notice.
In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the shareholders at their addresses
inscribed in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days before the proposed effective date
of the resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for
collective decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous
written resolution may be passed at any time without prior notice.
Except as otherwise provided for by law, (i) decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by
shareholders representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting or
first written resolution, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions
shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented. (ii) However, decisions
concerning the amendment of the articles of association are taken by (x) a majority of the shareholders (y) representing
128465
L
U X E M B O U R G
at least three quarters of the issued share capital and (iii) decisions to change of nationality of the Company are to be
taken by Shareholders representing one hundred percent (100%) of the issued share capital.
At no time shall the Company have more than thirty (30) shareholders. At no time shall an individual be allowed to
become a shareholder of the Company.
Art. 11. Accounting Year. The accounting year begins on 1
st
January of each year and ends on 31
st
December of the
same year save for the first accounting year which shall commence on the day of incorporation and end on 31
st
December
2014.
Art. 12. Financial Statements. Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the
manager or, as the case may be, the board of managers.
The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.
Art. 13. Distributions. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction
ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.
The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the manager,
or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood
that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by
profits carried forward and distributable reserves and premium but decreased by losses carried forward and sums to be
allocated to a reserve to be established by law.
The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal
reserve account.
Art. 14. Dissolution. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators
who may be but do not need to be shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders who will
specify their powers and remunerations.
Art. 15. Sole Shareholder. If, and as long as one shareholder holds all the shares of the Company, the Company shall
exist as a single shareholder company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10
th
August 1915 on commercial com-
panies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.
Art. 16. Applicable law. For anything not dealt with in the present articles of association, the shareholders refer to the
relevant legislation.
<i>Subscription and paymenti>
The articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the appearing party has
subscribed and entirely paid-up the following shares:
Subscriber
Number
of shares
Subscription
price (EUR)
BRE/Europe 7Q S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
EUR 12,500
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
EUR 12,500
Evidence of the payment of the total subscription price has been shown to the undersigned notary.
<i>Expenses, Valuationi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately one thousand four hundred Euros (EUR 1,400).
<i>Extraordinary general meetingi>
The sole shareholder has forthwith taken immediately the following resolutions:
1. The registered office of the Company is fixed at: 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
2. The following person is appointed manager of the Company for an undetermined period of time subject to the
articles of association of the Company with such signature powers as set forth in the articles of association of the Company:
- BRE/Management 7 S.A., a société anonyme incorporated under the laws of Luxembourg, with registered office at
2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg and being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in
Luxembourg under number B 180.304,
Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day before mentioned.
The document having been read to the appearing party, who requested that the deed should be documented in English,
the said appearing party signed the present original deed together with the notary, having personal knowledge of the
English language. The present deed, worded in English, is followed by a translation into German. In case of divergences
between the English and the German text, the English version will prevail.
128466
L
U X E M B O U R G
The document having been read to the appearing party, known to the notary by its name, first name, civil status and
residence, the said appearing party signed together with the notary the present deed.
Folgt die Deutsche Übersetzung des Vorstehenden Textes:
Im Jahre zweitausendvierzehn, am siebzehnten Tag des Monats Juli,
Vor dem unterzeichnenden Notar Maître Cosita Delvaux, mit Amtssitz in Redange-sur-Attert, Großherzogtum Lu-
xemburg,
ist erschienen,
BRE/Europe 7Q S.à r.l., eine société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) luxemburgischen
Rechts mit Sitz in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, deren Gesellschaftskapital zwölftausendfünfhundert Euro
(EUR 12.500) beträgt, und eingetragen ist im Registre de commerce et des sociétés in Luxembourg unter der Nummer
B 180.323,
hier vertreten durch Herrn Patrick Santer, maître en droit, beruflich wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer privat-
schriftlichen Vollmacht ausgestellt am 17ten Juli 2014, welche vorliegender Urkunde beigefügt ist um mit dieser bei der
Registrierungsbehörde eingereicht zu werden.
Die erschienene Partei hat in ihrer vorgenannten Eigenschaft den unterzeichnenden Notar ersucht, die Gründungs-
satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) "Argon Investment S.à r.l." wie folgt
zu beurkunden.
Art. 1. Gesellschaftsname. Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen
"Argon Investment S.à r.l." (die "Gesellschaft") wird hiermit von der erschienenen Partei und allen Personen, die gege-
benenfalls zukünftig als Gesellschafter eintreten, gegründet. Die Gesellschaft wird durch vorliegende Satzung und durch
die entsprechende luxemburgische Gesetzgebung geregelt.
Art. 2. Gesellschaftszweck. Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen in jeder beliebigen Form an in-
und ausländischen Gesellschaften sowie jede andere Form von Investitionen, sowie den Erwerb durch Kauf, Zeichnung
oder andere Art und Weise wie Übertragung durch Verkauf oder Tausch von Finanzinstrumenten jeder Art und die
Verwaltung, Aufsicht und Entwicklung ihres Portfolios.
Die Gesellschaft kann ebenfalls alle Transaktionen welche sich auf direkten oder indirekten Erwerb von Grundbesitz,
Eigentum, und Grundbesitzrechte in Luxemburg oder im Ausland oder auf den Erwerb von Beteiligungen an Unternehmen
welche im Besitz von Grundrechten sind oder von Unternehmensbeteiligungen jedweder Form beziehen, durchführen
sowie die Verwaltung, Aufsicht und Entwicklung dieser Beteiligungen und dieses Vermögen ausführen.
Die Gesellschaft kann Bürgschaften geben, Sicherheiten leisten, Darlehen ausgeben oder die Gesellschaften an denen
die Gesellschaft direkte oder indirekte Beteiligungen besitzt oder die zur Gruppe von Gesellschaften gehört, der die
Gesellschaft angehört, in jeder anderen Form unterstützen.
Die Gesellschaft kann außerdem in jeder beliebigen Form Darlehen erwerben, auch mit Preisnachlass, Darlehen ver-
geben, Kapital verleihen, sowie Vorschüsse gewährleisten oder unter jeglichen Konditionen Kredite vergeben, einschließ-
lich und ohne Einschränkungen derer Kredite, in Bezug auf ein Immobilien-Unternehmen oder -Unterfangen, die sich von
jeglichen Kreditaufnahmen der Gesellschaft oder von der Ausgabe von Kapital oder Schuldtitel jeglicher Art an alle Per-
sonen und Unternehmen, für die es für richtig empfunden wurde, ergeben. Die Gesellschaft kann Swaps, Futures,
Forwards, derivative Instrumente, Optionen, Rückkäufe, Wertpapierverleihe und ähnliche Transaktionen abschließen und
unbeschadet der Allgemeingültigkeit des Vorstehenden, jegliche Methode und Instrumente im Zusammenhang mit ihren
Immobiliengeschäften einsetzen. Die Gesellschaft kann auch jegliche Verträge über Garantien, Entschädigungen, Sicher-
heiten und alle weiteren äquivalente Verträge abschließen, so dass der Nutzen der, im Rahmen solcher Immobilienge-
schäfte vergebenen, Garantien und/oder Sicherheiten ihr zu Gute kommen kann. Die Gesellschaft kann im Rahmen solcher
Immobiliengeschäfte jegliche erforderliche Rolle übernehmen, einschließlich und ohne Einschränkungen der Rolle des
Arranger, lead Manager, Facility Agent, Security Agent, Documentation Agent. Die Gesellschaft wird die Tätigkeit der
Immobilienfinanzierung oder des Immobilienkrediterwerbs nicht in einer Weise ausüben, die eine Regulierung erfordern
würde gemäß der geänderten Fassung des Gesetzes des 5. Aprils 1993 bezüglich des Finanzsektors oder jeglichen zu-
künftigen Gesetzes oder Regulierungsmaßnahme, die dieses Gesetz abändern oder ersetzen sollte.
Die Gesellschaft kann alle geschäftlichen, technischen, finanziellen ebenso wie alle andere direkt oder indirekt ver-
bundenen Tätigkeiten welche die Erfüllung des Geschäftszwecks in den oben genannten Bereichen erleichtern, vorneh-
men.
Unter anderem wird die Gesellschaft allen Gesellschaften ihres Portfolios die für die Verwaltung, Entwicklung und
Aufsicht dieser Gesellschaften notwendigen Leistungen zur Verfügung stellen. Für diesen Zweck kann die Gesellschaft die
Unterstützung anderer Berater beanspruchen und auf solche zurückgreifen.
Art. 3. Geschäftsdauer. Die Gesellschaft ist auf unbegrenzte Dauer gegründet
Art. 4. Gesellschaftssitz. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg. Dieser kann,
durch Beschluss einer außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter die sich, in der für die Abänderung der
Satzung vorgesehenen Art und Weise beraten, an jeden Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.
128467
L
U X E M B O U R G
Der eingetragene Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss des Geschäftsführers, beziehungsweise durch die Ge-
schäftsführung innerhalb der Gemeinde verlegt werden.
Die Gesellschaft kann Geschäfts- und Zweigstellen in Luxemburg und im Ausland errichten.
Sollte der Geschäftsführer, oder im Falle einer Geschäftsführung die Geschäftsführung, feststellen, dass außerordent-
liche politische, wirtschaftliche oder soziale Ereignisse eingetreten sind oder unmittelbar bevorstehen welche die
normalen Tätigkeiten der Gesellschaft an ihrem eingetragenen Sitz oder die problemlose Kommunikation zwischen die-
sem Sitz und Personen im Ausland beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zum
vollständigen Ende solcher ungewöhnlichen Umstände ins Ausland verlegt werden; derartige vorläufige Maßnahmen haben
keine Auswirkung auf die staatliche Zugehörigkeit der Gesellschaft, die unbeschadet einer solchen vorübergehenden
Sitzverlegung eine luxemburgische Gesellschaft bleibt. Solche vorübergehenden Maßnahmen werden vom Geschäftsführer
oder, im Falle einer Geschäftsführung, von der Geschäftsführung vorgenommen und jeglichen betroffenen Personen mit-
geteilt.
Art. 5. Gesellschaftskapital. Das ausgegebene Gesellschaftskapital der Gesellschaft beläuft sich auf zwölftausendfünf-
hundert Euros (EUR 12.500), eingeteilt in fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je fünfund-
zwanzig Euros (EUR 25).
Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter in der für die Abänderung der
Satzung vorgesehenen Art und Weise erhöht oder verringert werden und die Gesellschaft kann seine anderen Gesell-
schaftsanteile durch Beschluss der Gesellschafter zurückkaufen.
Verfügbare Anteilsprämien können verteilt werden.
Art. 6. Übertragung der Anteile. Die Anteile sind unter den Gesellschaftern frei übertragbar. Soweit es das Gesetz
nicht anders bestimmt, bedarf die Übertragung von Anteilen auf Dritte der Einwilligung von Gesellschaftern, welche
zusammen mindestens fünfundsiebzig Prozent (75%) des Gesellschaftskapitals halten.
Art. 7. Geschäftsführung. Die Geschäftsführung der Gesellschaft erfolgt durch einen oder mehrere Geschäftsführer
die keine Gesellschafter sein müssen.
Der alleinige Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung ist mit den weitestreichenden Befugnissen aus-
gestattet, das Geschäft der Gesellschaft zu verwalten und ist dazu befugt, jede Handlungen und Tätigkeiten, die mit dem
Gegenstand der Gesellschaft im Einklang stehen, zu genehmigen und/oder auszuführen. Sämtliche Befugnisse, die nicht
ausdrücklich per Gesetz oder durch die vorliegende Satzung den Gesellschaftern vorbehalten sind, fallen in den Zustän-
digkeitsbereich des Geschäftsführers beziehungsweise der Geschäftsführung.
Gegenüber Dritten hat der Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung die weitestreichenden Befugnisse
um in allen Umständen, im Namen und Auftrag der Gesellschaft zu handeln und in jeden Umständen, jeden Akt und jede
Handlung, welche nicht durch die vorliegende Satzung oder durch die entsprechende luxemburgische Gesetzgebung im
Kompetenzbereich der Gesellschafterversammlung liegt, im Auftrag der Gesellschaft vorzunehmen, zu erlauben und gut-
zuheißen.
Die Geschäftsführer werden durch mehrheitlichen Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter gewählt und
abberufen, welche ihre Befugnisse und die Amtsdauer beschließt. Wenn keine Frist gesetzt wird, dann sind die Geschäfts-
führer auf unbestimmte Zeit ernannt. Die Geschäftsführer können wiedergewählt werden, jedoch kann ihre Ernennung
zu jeder Zeit mit oder ohne Grund (ad nutum) widerrufen werden.
Im Falle mehrerer Geschäftsführer bilden diese die Geschäftsführung. Jeder Geschäftsführer kann an jeder Sitzung der
Geschäftsführung teilnehmen mittels Telefonkonferenz oder anderen zur Verfügung stehenden Kommunikationsmitteln
insofern gewährleistet ist, dass alle an der Sitzung teilnehmenden Personen sich hören und miteinander kommunizieren
können. Eine Sitzung kann jederzeit mittels einer Telefonkonferenz oder ähnlichen Kommunikationsmitteln abgehalten
werden. Die Teilnahme oder das Abhalten einer Sitzung mit Hilfe dieser Mittel entspricht einer persönlichen Teilnahme
an der betroffenen Sitzung. Die Geschäftsführer können sich in den Sitzungen ohne Einschränkung der Anzahl der Voll-
machten durch einen anderen Geschäftsführer, der hierzu bevollmächtigt ist, vertreten lassen.
Die Geschäftsführer sind mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor Beginn einer Sitzung der Geschäftsführung
mittels schriftlicher Einberufung, zu benachrichtigen, außer in Notfällen, in welchem Fall die Art und die Gründe dieser
Umstände in der Einberufung erläutert werden müssen. Auf das Recht auf die oben beschriebene Weise einberufen zu
werden kann jeder Geschäftsführer durch schriftliche Zustimmung per Telegramm, Telekopie, Email, Telefax oder per
ähnlichem Kommunikationsmittel verzichten. Spezifische Einberufungen sind nicht notwendig für Sitzungen, welche vorher
zu einem durch Geschäftsführungsbeschluss genehmigten Zeitplan und zu vorgesehenen Zeiten und an vorbestimmten
Orten abgehalten werden.
Entscheidungen der Geschäftsführung werden durch die Mehrheit der Geschäftsführer der Gesellschaft gefasst.
Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden der Sitzung oder, in seiner Abwesenheit,
von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Protokolle werden vom Vorsitzenden oder von
zwei Geschäftsführern unterzeichnet.
Schriftliche Beschlüsse der Geschäftsführung können, aus einem einzigen oder mehreren einzelnen Dokumenten, gültig
abgeschlossen werden, wenn sie von allen Mitgliedern der Geschäftsführung schriftlich, per Telegramm, Telefax oder per
128468
L
U X E M B O U R G
ähnlichem Kommunikationsmittel genehmigt wurden. Die verschiedenen Dokumente gleichen Inhalts bilden zusammen
einen gültigen schriftlichen Beschluss. Beschlüsse der Geschäftsführung, einschließlich schriftliche Beschlüsse, können von
einem einzelnen Geschäftsführer beweiskräftig beglaubigt und ein Auszug davon beweiskräftig unterschrieben werden.
Die Gesellschaft wird durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder durch die Unterschrift eines einzel-
nen Geschäftsführers im Falle einer Geschäftsführung gebunden. Die Gesellschaft ist in jedem Fall wirksam durch die
Unterschrift einer oder mehrerer hierzu durch den alleinigen Geschäftsführer, beziehungsweise durch die Geschäftsfüh-
rung oder einer der Geschäftsführer, bevollmächtigten Personen, gebunden.
Art. 8. Haftung der Geschäftsführung. Die Geschäftsführer sind für Verschuldung der Gesellschaft nicht persönlich
haftbar. Als Vertreter der Gesellschaft sind sie jedoch für die Ausführung ihrer Aufgaben und Pflichten verantwortlich.
Vorbehaltlich den unten aufgeführten Ausnahmen und Beschränkungen, wird jede Person, die ein Geschäftsführer oder
leitender Angestellter der Gesellschaft ist oder war, von der Gesellschaft in vollem, gesetzlich erlaubten, Umfang gegen
Verbindlichkeiten und gegen alle Ausgaben, welche üblicherweise entstanden sind oder von ihm gezahlt wurden in Ver-
bindung mit Klagen, Prozessen oder Verfahren in die er als Partei oder anderweitig eintritt aufgrund dessen, dass er ein
Geschäftsführer oder leitender Angestellter ist oder gewesen ist und die diesbezüglich gezahlten Beträge oder von durch
deren Beilegung entstandenen Beträge, schadlos gehalten werden. Die Begriffe „Klage“, „Streitsache“, „Prozess“ oder
„Verfahren“ finden auf alle anhängigen oder bevorstehenden Klagen, Streitsachen, Prozesse oder Verfahren Anwendung
(zivilrechtlich, strafrechtlich oder sonstige, einschließlich Rechtsmittel) Anwendung und die Begriffe „Verbindlichkeit“ und
„Ausgaben“ beinhalten ohne Beschränkung Anwaltskosten, Prozesskosten, Sicherheitsleistungen, gezahlte Beträge bei
Streitbeilegung und andere Verbindlichkeiten.
Einem Geschäftsführer oder leitendem Angestellten wird keine Schadloshaltung gewährt:
(i) gegen Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschaft oder ihrer Gesellschafter, aufgrund von vorsätzlich begangenen
unerlaubten Handlungen, Bösgläubigkeit, grober Fahrlässigkeit oder rücksichtsloser Missachtung der Aufgaben, die in
seiner Amtsführung enthalten sind;
(ii) im Zusammenhang mit jeglichen Verfahren bei welchen er wegen bösgläubigem und nicht im Interesse der Gesell-
schaft erfolgtem Handeln, verurteilt wurde; oder
(iii) im Falle einer Beilegung, es sei denn die Beilegung ist von einem Gericht unter zuständiger Gerichtsbarkeit oder
von der Geschäftsführung genehmigt worden.
Das Recht der Schadloshaltung, das hier vorgesehen ist, ist abtrennbar und berührt keine anderen Rechte auf die das
Verwaltungsratsmitglied oder der leitende Angestellte jetzt oder später ein Anrecht hat, und soll fortgeführt werden in
der Person, die aufgehört hat, ein Geschäftsführer oder leitender Angestellter zu sein und soll dem Vorteil der Erben,
Testamentsvollstreckern und Verwaltern einer solchen Person dienen. Nichts hierin Enthaltenes berührt die Rechte zur
Schadloshaltung, auf die Gesellschaftspersonal, eingeschlossen Geschäftsführer und leitende Angestellte, aufgrund von
Vertrag oder anderweitig durch Gesetz, Anspruch haben könnten.
Ausgaben in Verbindung mit Vorbereitung und Vertretung der Verteidigung einer Klage, Streitsache, Prozess oder
Verfahren beschrieben in diesem Artikel, soll von der Gesellschaft vor der endgültigen Verfügung darüber bei Zugang
jeglicher Unternehmung seitens oder im Namen eines leitenden Angestellten oder Geschäftsführers vorgestreckt werden,
um den benannten Betrag zurückzuzahlen wenn es letztlich bestimmt ist, dass er keinen Anspruch auf Schadloshaltung
unter diesem Artikel hat.
Art. 9. Stimmrechte der Gesellschafter. Jeder Gesellschafter kann an kollektiven Entscheidungen teilnehmen. Die Zahl
seiner Stimmen entspricht der Zahl seiner Gesellschaftsanteile und der Gesellschafter kann bei jeder Versammlung durch
eine spezielle Vollmacht vertreten werden.
Art. 10. Gesellschafterversammlungen. Die Beschlüsse der Gesellschafter werden in der im luxemburgischen Gesell-
schaftsrecht vorgeschriebenen Form und mit der darin vorgesehenen Mehrheit, schriftlich (soweit dies gesetzlich möglich
ist) oder in Gesellschafterversammlungen, gefasst. Jede ordnungsgemäß konstituierte Gesellschafterversammlung der
Gesellschaft beziehungsweise jeder ordnungsgemäß schriftlicher Beschluss vertritt die Gesamtheit der Gesellschafter der
Gesellschaft.
Die Einberufung der Versammlungen durch den Geschäftsführer/die Geschäftsführung hat mindestens acht (8) Tage
vor der Versammlung mittels eingeschriebenen Briefes an die Gesellschafter an ihre im Anteilsregister der Gesellschaft
eingetragene Adresse, zu erfolgen. Wenn das gesamte Gesellschaftskapital der Gesellschaft vertreten ist, kann die Sitzung
ohne vorherige Einberufung abgehalten werden.
Werden Beschlüsse im Wege eines Zirkularbeschlusses der Gesellschafter gefasst, so wird der Inhalt des Beschlusses
mindestens acht (8) Tage bevor der Beschluss wirksam werden soll, an alle Gesellschafter an ihre im Anteilsregister
eingeschriebene Adresse mittels eingeschriebenen Briefs übersandt. Die Beschlüsse werden wirksam bei Zustimmung
der vom Gesetz vorgesehenen Mehrheiten für gemeinsame Entscheidungen (oder, unter der Voraussetzung der Befrie-
digung der Mehrheitsvoraussetzungen, am in dieser Entscheidung festgelegten Tag). Einstimmige Zirkularbeschlüsse
können jederzeit ohne vorherige Ankündigung getroffen werden.
Soweit gesetzlich nichts anderes vorgesehen ist, (i) werden die in den Gesellschafterversammlungen zu fassenden
Beschlüsse von den Gesellschaftern getroffen, welche mehr als die Hälfte des Geschäftskapitals vertreten. Wird eine
128469
L
U X E M B O U R G
solche Mehrheit bei der ersten Gesellschafterversammlung nicht erreicht, werden die Gesellschafter per Einschreiben zu
einer zweiten Gesellschafterversammlung geladen und die Beschlüsse werden sodann aufgrund der Mehrheit der abge-
gebenen Stimmen gefasst, unbeschadet der Anzahl der vertretenen Geschäftsanteile. (ii) Die Satzung kann jedoch nur mit
Zustimmung (x) der Mehrheit der Gesellschafter, welche (y) zwei Drittel des Gesellschaftskapitals vertreten, abgeändert
werden und (iii) Entscheidungen, die Nationalität der Gesellschaft zu ändern, bedürfen der Zustimmung von Gesellschaf-
tern, die einhundert Prozent (100%) des Gesellschaftskapitals vertreten.
Zu keiner Zeit soll die Gesellschaft mehr als dreißig (30) Gesellschafter haben. Zu keiner Zeit soll es einer natürlichen
Person gestattet sein, ein Gesellschafter der Gesellschaft zu werden.
Art. 11. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten (1.) Januar und endet am einunddreißigsten (31.) Dezember
eines jeden Jahres. Das erste Geschäftsjahr, welches am Tage der Gründung der Gesellschaft beginnt, wird am 31. De-
zember 2014 enden.
Art. 12. Jahresabschluss. Der alleinige Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung erstellt jedes Jahr die
Jahresabrechnung der Gesellschaft.
Jeder Gesellschafter kann die Jahresabrechnung am Sitz der Gesellschaft einsehen.
Art. 13. Gewinnverwendung. Fünf Prozent (5%) des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft werden der gesetzlich
vorgeschriebenen Rücklage zugeführt. Diese Rücklageeinzahlungspflicht besteht nicht mehr, sobald die gesetzliche Rück-
lage zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.
Die Gesellschafter können auf der Grundlage eines von dem alleinigen Geschäftsführer, beziehungsweise der Ge-
schäftsführung angefertigten Zwischenabschlusses die Ausschüttung von Abschlagsdividenden beschließen, sofern dieser
Zwischenabschluss zeigt, dass ausreichend Gewinne und andere Reserven zur Ausschüttung zur Verfügung stehen, wobei
der auszuschüttende Betrag die seit dem Ende des vorhergehenden Geschäftsjahres erzielten Gewinne, für welches die
Jahresabschlüsse bereits bewilligt wurden, erhöht um die vorgetragenen Gewinne und ausschüttbaren Rücklagen, ver-
mindert um die vorgetragenen Verluste und die der gesetzlichen Rücklage zuzuführenden Beträge, nicht übersteigen darf.
Der Saldo kann nach Entscheidung der Gesellschafterversammlung an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.
Das Anteilsprämienkonto kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung an die Gesellschafter ausgeschüttet
werden. Die Gesellschafterversammlung kann beschließen, jeden Betrag vom Anteilsprämienkonto auf die gesetzliche
Rücklage zu übertragen.
Art. 14. Auflösung. Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft ernennen die Gesellschafter einen oder mehrere Liqui-
datoren, bei welchen es sich nicht um Gesellschafter handeln muss, zwecks der Durchführung der Auflösung und
bestimmen ihre Befugnisse und Vergütung.
Art. 15. Alleingesellschafter. Sofern nur ein Gesellschafter alle Geschäftsanteile der Gesellschaft hält, gilt Artikel 179
(2) des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften und die Artikel 200-1 und 200-2 finden u.a. Anwendung.
Art. 16. Anwendbares Recht. Sämtliche nicht ausdrücklich durch diese Satzung geregelten Angelegenheiten richten
sich nach den entsprechenden Regelungen des anwendbaren Gesetzes.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Nach dem die erschienene Partei die Gründungssatzung erstellt hat, hat sie das gesamte Gesellschaftskapital wie folgt
eingezahlt und gezeichnet:
Einzahler
Zahl der
Geschäftsanteile
Einzahlungspreis
(EUR)
BRE/Europe 7Q S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
EUR 12.500
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
EUR 12.500
Ein Beleg für die vollständige Einzahlung der Geschäftsanteile wurde dem unterzeichneten Notar vorgelegt.
<i>Kostenschätzungi>
Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund der vorlie-
genden Gesellschaftsgründung entstehen, werden auf ungefähr vierzehnhundert Euro (EUR 1.400) geschätzt.
<i>Ausserordentliche Beschlüsse des Gesellschaftersi>
Unverzüglich nach der Gründung der Gesellschaft hat der Alleinige Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:
1. Sitz der Gesellschaft ist in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg.
2. Die folgende Person wird für einen unbeschränkten Zeitraum zum Geschäftsführer der Gesellschaft mit der in der
Satzung der Gesellschaft beschriebenen Unterschriftsbefugnis ernannt:
- BRE/Management 7 S.A., eine Aktiengesellschaft (société anonyme) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 2-4, rue
Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg und eingetragen im Registre de Commerce et des Sociétés in Luxemburg unter der
Nummer B 180.304.
128470
L
U X E M B O U R G
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnende Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass auf Ersuchen der oben erschie-
nenen Partei, die vorliegende Urkunde in English abgefasst wird, gefolgt von einer deutschen Übersetzung.
Auf Ersuchen derselben erschienenen Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deut-
schen Text, ist die englische Fassung maßgebend.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die erschienene Partei die dem amtierenden Notar nach
Namen, Vornamen, Zivilstand und Wohnort bekannt, hat dieselbe zusammen mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.
Gezeichnet: P. SANTER, C. DELVAUX.
Enregistré à Redange/Attert, le 21 juillet 2014. Relation: RED/2014/1589. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): T. KIRSCH.
FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum
Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Redange-sur-Attert, den 25. Juli 2014.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2014109102/452.
(140131873) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2014.
SDA International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 16.400,00.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 181.339.
In the year two thousand and fourteen, on the seventeenth day of July.
Before Maître Francis Kesseler, notary established in Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Mediterra Capital Partners I, LP, registered as a limited partnership in England, under the limited Partnerships Act 1907
with number LP014244, whose principal place of business is at Heritage Hall, PO Box 225, Le Marchant Street, St Peter
Port, Guernsey GY1 4HY, acting through its general partner Mediterra Capital Partners GP, LP, registered with the
Registrar of Limited Partnerships at Companies House in Edinburgh under number 8498, the latter acting in turn through
its general partner Mediterra Capital Management Limited, registered with the Guernsey Registry under number 52755
(the “Sole Shareholder”);
represented here by Ms. Claudia Rouckert, notary clerk, with professional address at 5, rue Zénon Bernard, L-4030
Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.
Such proxy having been signed “ne varietur” by the proxy-holder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to this deed to be filed with it with the registration authorities.
The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record as follows:
I.- The appearing party is the sole shareholder of SDA International S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité
limitée having its registered office at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duchy of
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 181.339 (the “Company”),
incorporated by a deed enacted by the undersigned notary on 07 October 2013, published in the “Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations” number 3205 on 17 December 2013. The articles of association of the Company have not
been amended since.
II.- The 12,500 (twelve thousand five hundred) shares with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each, representing
the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the
agenda of which the Sole Shareholder expressly states having been duly informed beforehand.
III.- The agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Waiving of notice right;
2. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 3,900 (three thousand nine hundred Euros) so
as to raise it from its current amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euros) to EUR 16,400 (sixteen
thousand four hundred Euros) by the issuance of 3,900 (three thousand nine hundred) new shares with a nominal value
of EUR 1 (one Euro) each, subject to the payment of a global share premium amounting to EUR 148,094 (one hundred
forty-eight thousand ninety-four Euros) payable on the share premium account of the Company, out of which an amount
of EUR 1,640 (one thousand six hundred forty Euros) shall be allocated to the legal reserve, the whole to be fully paid
up through a contribution in kind;
3. Subscription and payment by Mediterra Capital Partners I, LP of the new shares by way of a contribution in kind;
128471
L
U X E M B O U R G
4. New composition of the shareholding of the Company;
5. Subsequent amendment of the first paragraph of article 8 of the articles of association of the Company; and
6. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolutions have been taken:
<i>First resolution:i>
It is resolved that the Sole Shareholder waives its right to the prior notice of the current meeting, acknowledges being
sufficiently informed on the agenda, considers being validly convened and therefore agrees to deliberate and vote upon
all the items of the agenda. It is further resolved that all the relevant documentation has been put at the disposal of the
Sole Shareholder within a sufficient period of time in order to allow it to examine carefully each document.
<i>Second resolution:i>
It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 3,900 (three thousand nine hundred
Euros) so as to raise it from its current amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euros) to EUR 16,400
(sixteen thousand four hundred Euros) by the issuance of 3,900 (three thousand nine hundred) new shares with a nominal
value of EUR 1 (one Euro) each (the “New Shares”), to be fully paid up through a contribution in kind as described below
(the “Contribution”), subject to the payment of a global share premium amounting to EUR 148,094 (one hundred forty-
eight thousand ninety-four Euros) payable on the share premium account of the Company (the “Share Premium”), out
of which EUR 1,640 (one thousand six hundred forty Euros) shall be allocated to the legal reserve.
<i>Third resolution:i>
It is resolved to accept the subscription and the payment by the Sole Shareholder of the New Shares and the Share
Premium through the Contribution as described below.
<i>Intervention - Subscription - Paymenti>
Thereupon intervenes the Sole Shareholder, here represented by Ms. Claudia Rouckert, prenamed, by virtue of a
proxy given under private seal who declares to subscribe to the New Shares. The New Shares and the Share Premium
have been fully paid up by the Sole Shareholder through the Contribution as described below.
<i>Description of the Contributioni>
The Contribution made by the Sole Shareholder, in exchange for the issuance of the New Shares and the payment of
the Share Premium, is composed of a receivable held by the Sole Shareholder against the Company.
<i>Valuationi>
The Contribution is valued at an aggregate amount of EUR 151,994 (one hundred fifty-one thousand nine hundred
ninety-four Euros).
Such valuation has been approved by the managers of the Company pursuant to a statement of contribution value
dated 20 June 2014 and which shall remain annexed to this deed to be submitted with it to the formality of registration.
<i>Evidence of the Contribution's existencei>
A proof of the existence of the Contribution has been given to the Company.
<i>Managers' interventioni>
Thereupon intervene:
a) Mr. Ahmet Faralyali, residing professionally at Heritage Hall Le Marchant Street St Peter Port Guernsey GY1 4HY,
category A manager;
b) Mr. Frank Werner Pletsch, residing professionally at 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L- 1331 Luxem-
bourg, Grand-Duchy of Luxembourg, category B manager;
c) Mr. Gérard Bruno Birchen, residing professionally at 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L- 1331 Luxem-
bourg, Grand-Duchy of Luxembourg, category B manager;
all represented here by Ms. Claudia Rouckert, prenamed, by virtue of a proxy contained in the above statement of
contribution value.
Acknowledging having been previously informed of the extent of their responsibility, legally bound as managers of the
Company by reason of the Contribution, expressly agree with the description of these Contribution, with their valuation,
and confirm the validity of the subscription and payment.
<i>Fourth resolution:i>
As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the shareholding of the Company is now composed
of:
- Mediterra Capital Partners I, LP: 16,400 (sixteen thousand four hundred) shares.
128472
L
U X E M B O U R G
The notary acts that the 16,400 (sixteen thousand four hundred) shares representing the whole share capital of the
Company, are represented so that the meeting can validly decide on the resolution to be taken below.
<i>Fifth resolution:i>
As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the Contribution having been fully carried out, it
is resolved to amend the first paragraph of article 8 of the Company's articles of association so as to read as follows:
“ Art. 8. The capital is set at EUR 16,400 (sixteen thousand four hundred Euros) divided into 16,400 (sixteen thousand
four hundred) shares of EUR 1 (one Euro) each.”
No other amendment is to be made to this article.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon closed.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the day named at the beginning of this
document.
The document having been read to the proxy-holder of the person appearing, such proxy-holder of the person ap-
pearing signed together with us, the notary, the present original deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la version française du texte qui précède
L'an deux mille quatorze, le dix-septième jour de juillet.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
Mediterra Capital Partners I, LP, immatriculée en tant que société en commandite en Angleterre, sous la loi de 1907
sur les sociétés en commandite (the “limited Partnerships Act 1907”) sous le numéro LP014244, ayant son centre principal
d'activité sis à Heritage Hall, PO Box 225, Le Marchant Street, St Peter Port, Guernsey GY1 4HY, agissant par l'inter-
médiaire de son associé commandité Mediterra Capital Partners GP, LP, immatriculé auprès du registre des sociétés
(Companies House) à Edimbourg sous le numéro 8498, ce dernier agissant à son tour par l'intermédiaire de son associé
commandité Mediterra Capital Management Limited immatriculé auprès du Registre de Guernsey sous le numéro 52755
(«l'Associé Unique»);
ici représentée par Mlle. Claudia Rouckert, clerc de notaire, ayant son adresse professionnelle au 5, rue Zénon Bernard,
L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
Ladite procuration ayant été paraphée "ne varietur" par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante
et le notaire soussigné, demeurera annexée au présent acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités de l'enregis-
trement.
La partie comparante, représentée tel que décrit ci-dessus, a requis du notaire soussigné d'acter ce qui suit:
I - La partie comparante est l'Associé Unique de «SDA International S.à r.l.», une société à responsabilité limitée
luxembourgeoise, ayant son siège social au 65 Boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duché
de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg au numéro B 181.339 (la
«Société»), constituée par acte notarié le 07 octobre 2013, publié au “Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations”,
numéro 3205 le 17 Décembre 2013. Les statuts de la Société n'ont pas été modifiés depuis.
II - Que les 12,500 (douze mille cinq cents) parts sociales ayant une valeur nominale de 1 (un Euro) chacune, repré-
sentant la totalité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer
sur tous les points de l'ordre du jour, dont l'Associé Unique reconnaît avoir été dûment préalablement informé.
III - L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Renonciation au droit de convocation;
2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de 3900 EUR (trois mille neuf cents Euros) afin de le
porter de son montant actuel de 12 500 (douze mille cinq cents Euros) à 16 400 (seize mille quatre cent Euros) par
l'émission de 3900 (trois mille neuf cents) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de 1 EUR (un Euro) chacune,
moyennant le paiement d'une prime globale d'émission d'un montant de 148 094 EUR (cent quarante-huit mille quatre-
vingt quatorze Euros) exigible sur le compte de prime d'émission de la Société, duquel un montant de 1 640EUR (mille
six cent quarante Euros) sera alloué à la réserve légale de la Société, le tout devant être payé au moyen d'un apport en
nature;
3. Souscription et paiement par Mediterra Capital Partners I, LP des nouvelles parts sociales au moyen d'un apport en
nature;
4. Nouvelle composition de l'actionnariat de la société
5. Modification subséquente du premier paragraphe de l'article 8 des statuts de la Société; et
128473
L
U X E M B O U R G
6. Divers.
Suite à l'approbation de ce qui précède par l'Associé Unique, les résolutions suivantes ont été adoptées:
<i>Première résolution:i>
Il est décidé que l'Associé Unique renonce à son droit de convocation préalable à la présente assemblée, et reconnaît
avoir été suffisamment informé de l'ordre du jour et considère avoir été valablement convoqué et en conséquence accepte
de délibérer et voter sur tous les points figurant à l'ordre du jour. Il est en outre décidé que toute la documentation
pertinente a été mise à la disposition de l'Associé Unique dans un délai suffisant afin de lui permettre un examen attentif
de chaque document.
<i>Deuxième résolution:i>
Il est décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 3 900 EUR (trois mille neuf cent Euros) afin
de le porter de son montant actuel de 12.500 (douze mille cinq cents Euros) à 16 400 (seize mille quatre cents Euros)
par l'émission de 3 900 (trois mille neuf cents) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de 1 EUR (un Euro) chacune,
(les «Parts Sociales Nouvelles»), devant être entièrement libérées par un apport en nature tel que décrit ci-dessous
(l'«Apport»), sous réserve du paiement d'une prime d'émission globale s'élevant à 148 094 EUR (cent quarante-huit mille
quatre-vingt quatorze Euros) payable sur le compte de prime d'émission de la Société (la «Prime d'Emission»), duquel un
montant de 1 640 (mille six cent quarante Euros) sera alloué à la réserve légale de la Société.
<i>Troisième résolution:i>
Il est décidé d'accepter la souscription et le paiement par l'Associé Unique des Parts Sociales Nouvelles ainsi que de
la Prime d'Emission au moyen de l'Apport tel que décrit ci-dessous.
<i>Intervention de l'apporteur - Souscription - Paiementi>
Intervient ensuite l'Associé Unique, ici représenté par Mlle. Claudia Rouckert, précitée, en vertu d'une procuration
donnée sous seing privé qui déclare souscrire les Parts Sociales Nouvelles. Les Parts Sociales Nouvelles et la Prime
d'Emission ont été entièrement libérées par l'Associé Unique par le biais de l'Apport tel que décrit ci-dessous.
<i>Description de l'Apporti>
L'Apport fait par l'Associé Unique, en contrepartie de l'émission des Parts Sociales Nouvelles et du paiement de la
Prime d'Emission, est composé d'une créance détenue par l'Associé Unique à l'encontre de la Société.
<i>Evaluationi>
L'Apport est évalué à un montant de 151 994 EUR (cent cinquante et un mille neuf cent quatre-vingt quatorze Euros).
Une telle évaluation a été approuvée par les gérants de la Société conformément à une déclaration de valeur de l'Apport
datée du 20 juin 2014, et qui devra rester annexée à cet acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités de l'enre-
gistrement.
<i>Preuve de l'existence de l'Apporti>
Une preuve de l'existence de l'Apport a été donnée à la Société.
<i>Intervention des gérantsi>
Interviennent alors:
a) M. Ahmet Faralyali, domicilié professionnellement à Heritage Hall, Le Marchant Street, St Peter Port, Guernesey
GY1 4HY, gérant de catégorie A;
b) M. Frank Werner Pletsch, domicilié professionnellement au 65 boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, gérant de catégorie B;
c) M. Gérard Bruno Birchen, domicilié professionnellement au 65 boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, gérant de catégorie B;
tous représentés par Mlle. Claudia Rouckert, précitée, en vertu d'une procuration incluse dans la déclaration de valeur
d'apport mentionnée ci-dessus.
Reconnaissant avoir été préalablement informés de l'étendue de leur responsabilité, légalement responsables en tant
que gérants de la Société en raison de l'Apport, ils se déclarent expressément d'accord avec la description de cet Apport,
avec son évaluation, et confirment la validité de la souscription et du paiement.
<i>Quatrième résolution:i>
En conséquence des déclarations et résolutions qui précèdent, l'actionnariat de la Société est désormais composé de:
- Mediterra Capital Partners I, L.P.: 16 400 (seize mille quatre cents) parts sociales.
Le notaire acte que les 16 400 (seize mille quatre cents) parts sociales représentant la totalité du capital social de la
Société sont représentées de telle sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer sur la résolution devant être
prise ci-après.
128474
L
U X E M B O U R G
<i>Cinquième résolution:i>
En conséquence des déclarations et résolutions qui précédent l'Apport ayant été entièrement libéré, il est décidé de
modifier le premier paragraphe de l'article 8 des statuts de la Société de la Société de manière à le lire comme suit:
“ Art. 8. Le capital de la Société est fixé à 16 400 EUR (seize mille quatre cents Euros), représenté par 16 400 (seize
mille quatre cents) parts sociales d'une valeur nominale de 1 EUR (un Euro) chacune.”
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont Acte, fait et rédigé à Esch-sur-Alzette, au jour indiqué en tête du présent document.
Lecture ayant été faite de ce document au mandataire de la personne présente, elle a signé avec nous, notaire, l'original
du présent acte.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par le présent acte qu'à la requête des personnes com-
parantes les présents Statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française. A la requête de la même personne et
en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Signé: Rouckert, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 22 juillet 2014. Relation: EAC/2014/10192. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveur ff.i>
(signé): M. Halsdorf.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2014110973/217.
(140132729) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2014.
Fior Ateliers S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4959 Bascharage, Zone Artisanale Op Zaemer.
R.C.S. Luxembourg B 77.353.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE ROLAND KOHN S.à.r.l.
259 ROUTE D’ESCH
L-1471 LUXEMBOURG
Signature
Référence de publication: 2014118326/13.
(140136614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2014.
FGL Lux Holdings, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 158.497.
In the year two thousand and fourteen, on the twenty-fourth day of the month of July,
Before Maître Edouard Delosch, notary, residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg,
There appeared:
Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation, a Japanese corporation incorporated under the laws of Japan, with
registered office at 4-5, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, J-100-8212 Tokyo, Japan being represented by Véronique
Pourtier, juriste, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy dated 17 July 2014 (which after being signed
ne varietur shall remain attached to the present deed to be submitted together with it to the registration formalities),
being the sole shareholder (the “Sole Shareholder”) of FGL Lux Holdings, S.à r.l. (the “Company”), a société à respon-
sabilité limitée duly organised and existing under the laws of Luxembourg, with its registered office at 287-289 route
d’Arlon, L-1150 Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number
B 158.497, incorporated by a deed of Maître Henri Hellinckx notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg, on 25 January 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the “Mémorial C”) number
566 of 25 March 2011. The articles of association of the Company have been amended several times and for the last time
by a deed of the prenamed notary on 23 September 2013, published in the Mémorial C number 3006 on 28 November
2013.
The appearing party declared and requested the notary to record that the Sole Shareholder holds all twenty thousand
one (20,001) shares with a par value of one USD (US $ 1) each, so that the decisions can validly be taken on the following
item:
128475
L
U X E M B O U R G
<i>Agenda:i>
1) Approval of the reduction of the current issued share capital of the Company by an amount of one US Dollar (USD
1) so as to bring it from its current amount of twenty thousand one US Dollars (USD 20,001) to twenty thousand US
Dollars (USD 20,000) by the cancellation of one (1) share of a nominal value of one US Dollar (USD 1);
2) Consequential amendment of article 5 of the articles of association of the Company;
3) Decision to dissolve the Company and put it into liquidation; and
4) Appointment of Hisakata Isomura as liquidator of the Company and determination of the powers of the liquidator
granting the liquidator the largest powers provided for by law.
Thereafter the following resolutions were passed:
<i>First resolutioni>
It is proposed that the share capital of the Company be reduced by an amount of one US Dollar (USD 1) so as to
bring it from its current amount of twenty thousand one US Dollars (USD 20,001) to twenty thousand US Dollars (USD
20,000) (the “Share Capital Reduction”).
The Sole Shareholder decided to proceed to the Share Capital Reduction by the cancellation of one (1) share of a
nominal value of one US Dollar (USD 1) and to implement the Share Capital Reduction by the distribution to the Sole
Shareholder of shares held by the Company in Mitsubishi UFJ Fund Services Holdings Limited, its Bermuda subsidiary.
<i>Second resolutioni>
As a result of the resolution hereabove, the Sole Shareholder decided to amend article 5 of the articles of association
of the Company so as to read as follows:
“ Art. 5 Capital.
5.1. The share capital is set at twenty thousand United States Dollars (USD 20,000), represented by twenty thousand
(20,000) shares with a par value of one United States Dollar (USD 1) each, all subscribed and fully paid-up.
5.2. The share capital may be increased or decreased in one or several times by a resolution of the shareholders, acting
in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.”
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder decided to dissolve the Company and put it into liquidation. The Sole Shareholder noted that
the Company shall subsist for the sole purpose of its liquidation.
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to appoint as liquidator of the Company Hisakata Isomura, being the sole manager of
the Company, having his professional address at 16 rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
The Sole Shareholder further resolved to grant the largest powers, and particularly those set forth in articles 144 and
following of the law of 10
th
August 1915 on commercial companies, as amended, to the liquidator, and to authorise the
liquidator in advance to execute the acts and enter into the deeds set forth in article 145 of the same law without any
special authorisation from the Sole Shareholder, if such authorisation is required by law.
The Sole Shareholder dispenses the liquidator from drawing up an inventory and agrees that the liquidator may refer
to the books of the Company.
The liquidator may delegate, under his responsibility, all or part of his powers to one or more proxies with respect
to specific acts or deeds.
The liquidator is authorised to proceed to any interim liquidation surplus payments as the liquidator deems fit.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of the above resolutions are estimated at approximately one thousand two hundred Euro (EUR 1,200.-).
Whereof, the present notarial deed is drawn up in Luxembourg on the day indicated at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states that the present deed is worded in English followed
by a French translation; at the request of the appearing person, the English text shall prevail in case of any discrepancy
between the English and the French texts.
This document having been read to the appearing person, who is known to the notary by its respective name, first
name, civil status and residence, the said person signed this original deed with us, the notary.
Suit la traduction française du texte qui précède
L’an deux mille quatorze, le vingt-quatrième jour du mois de juillet,
par-devant Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg,
128476
L
U X E M B O U R G
a comparu:
Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation, une société japonaise constituée en vertu des lois du Japon, dont le
siège social est situé au 4-5, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, J-100-8212 Tokyo, Japon, représentée par Véronique
Pourtier, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une procuration datée du 17 juillet 2014
(laquelle, après avoir été signé ne varietur, restera annexée au présent acte afin d’être soumise aux formalités de l'enre-
gistrement avec celui-ci), étant l'associé unique (l'«Associé Unique») de FGL Lux Holdings, S.à r.l. (la «Société»), une
société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé au 287-289, route d’Arlon, L-1150
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 158.497, constituée le 25 janvier 2011 suivant acte reçu de Maître Henri Hellinckx notaire de
résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le
«Mémorial C») numéro 566 du 25 mars 2011. Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la
dernière fois le 23 septembre 2013 suivant acte reçu du notaire précité et publié au Mémorial C numéro 3006 du 28
novembre 2013.
La partie comparante a déclaré et requis le notaire d’acter que l'Associé Unique détient la totalité des vingt mille une
(20.001) parts sociales d’une valeur nominale d’un dollar américain (1,00 USD) chacune, de sorte que les décisions peuvent
être prises valablement sur l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
5) Approbation de la réduction du capital social émis actuel de la Société d’un montant d’un dollar américain (1 USD)
afin de le porter de son montant actuel de vingt mille un dollars américains (20.001 USD) à vingt mille dollars américains
(20.000 USD) par l'annulation d’une (1) part sociale d’une valeur nominale d’un dollar américain (1 USD);
6) Modification en conséquence de l'article 5 des statuts de la Société;
7) Décision de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation; et
8) Nomination de Hisakata Isomura en tant que liquidateur de la Société et détermination des pouvoirs du liquidateur,
lui accordant les pouvoirs les plus étendus prévus par la loi.
À la suite de quoi, les résolutions suivantes ont été adoptées:
<i>Première résolutioni>
Il est proposé que le capital social de la Société soit réduit d’un montant d’un dollar américain (1 USD) afin de le porter
de son montant actuel de vingt mille un dollars américains (20.001 USD) à vingt mille dollars américains (20.000 USD)
(la «Réduction du Capital Social»).
L’Associé Unique a décidé de procéder à la Réduction du Capital Social par l'annulation d’une (1) part sociale d’une
valeur nominale d’un dollar américain (1 USD) et d’exécuter la Réduction du Capital Social par la distribution à l'Associé
Unique de parts sociales que la Société détient dans Mitsubishi UJF Fund Services Holdings Limited, sa filiale bermudienne.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution ci-dessus, l'Associé Unique a décidé de modifier l'article 5 des statuts de la Société afin qu’il ait la
teneur suivante:
« Art. 5 Capital.
5.1. Le capital social est fixé à vingt mille dollars américains (20.000 USD), représenté par vingt mille (20.000) parts
sociales ayant une valeur nominale d’un dollar américain (1,00 USD) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.
5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée
selon les modalités requises pour la modification des Statuts.»
<i>Troisième résolutioni>
L’Associé Unique a décidé de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation. L’Associé Unique a pris acte du fait
que la Société ne subsistera que pour les seuls besoins de la liquidation.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Associé Unique a décidé de nommer en tant que liquidateur de la Société Hisakata Isomura, étant le gérant unique
de la Société, dont l'adresse professionnelle se situe au 16 rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
L’Associé Unique a ensuite décidé d’accorder les pouvoirs les plus étendus, et notamment ceux prévus aux articles
144 et suivants de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, au liquidateur, et
d’autoriser par avance le liquidateur à accomplir les actes et conclure les contrats prévus à l'article 145 de la même loi
sans devoir recourir à l'autorisation spéciale de l'Associé Unique, dans le cas où celle-ci est requise pas la loi.
L’Associé Unique dispense le liquidateur de dresser un inventaire et accepte que le liquidateur puisse se référer aux
livres de la Société.
Le liquidateur peut, sous sa responsabilité, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataire(s)
pour des actes ou contrats spécifiques.
128477
L
U X E M B O U R G
Le liquidateur est autorisé à procéder à tout paiement intermédiaire du boni de liquidation tel qu’il l'estime opportun.
<i>Dépensesi>
Les dépenses, frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incomberont à la Société en raison
des résolutions ci-dessus, sont estimés à approximativement mille deux cents euros (1.200,-€).
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que le présent acte est rédigé en anglais, suivi d’une
traduction en langue française; à la demande de la personne comparante, en cas de divergences entre les versions anglaise
et française, la version anglaise fera foi.
Après lecture faite du document à la personne comparante, connue du notaire par son nom, prénom, état civil et
résidence, ladite personne et le notaire ont signé le présent acte original.
Signé: V. POURTIER, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 25 juillet 2014. Relation: DIE/2014/9546. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.
<i>Le Receveuri>
(signé) pd: RECKEN.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Diekirch, le 29 juillet 2014.
Référence de publication: 2014117247/146.
(140134949) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2014.
Fondation AGGL - FNEL, Fondation.
Siège social: L-1741 Luxembourg, 43, rue de Hollerich.
R.C.S. Luxembourg G 77.
L'an deux mille quatorze, le vingt-sept février.
Pardevant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) Monsieur Pierre MATAGNE, Président du Conseil d'administration, demeurant à Imbringen,
2) Monsieur Robert LOOS, Secrétaire du Conseil d'administration, demeurant à Neihaischen,
agissant au nom et pour compte de la Fondation FNEL, établie et ayant son siège social à Luxembourg.
Lesquels comparants ont déclaré que:
- le conseil d’administration de la Fondation FNEL, après en avoir délibéré, la majorité de ses membres étant présents
ou représentés (11 membres présents ou représentés à la réunion du 19 juin 2012 et 10 membres présents ou représentés
à la réunion du 25 juillet 2012), a décidé à l'unanimité des membres du Conseil présents ou représentés lors de ses
réunions du 19 juin 2012 (premier vote) et du 25 juillet 2012 (second vote), de modifier les statuts de la Fondation FNEL,
- le conseil d’administration de la Fondation FNEL, après en avoir délibéré, la majorité de ses membres étant présents
ou représentés (9 membres présents ou représentés à la réunion du 31 janvier 2013 et 11 membres présents ou repré-
sentés à la réunion du 7 mars 2013), a décidé à l'unanimité des membres du Conseil présents ou représentés lors de ses
réunions du 31 janvier 2013 (premier vote) et du 7 mars 2013 (second vote), d’approuver les modifications apportées
aux modifications statutaires projetées (article 1, 4, 7 et 13) à la demande du Ministère de la Justice suivant courriers des
10 décembre 2012 et 25 janvier 2013,
de sorte que les statuts de la Fondation FNEL auront désormais la teneur suivante:
Chapitre I
er
. Dénomination - Siège - Durée
Art. 1
er
. La fondation prend la dénomination de "FONDATION AGGL- FNEL" (ci-après désignée la "Fondation").
Le siège de la Fondation se situe dans la commune de Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre endroit du
Grand-Duché par décision du conseil d’administration rédigée par acte notarié et approuvée par arrêté grand-ducal. La
durée de la Fondation est illimitée.
Chapitre II. Objet
Art. 2. La Fondation a pour objet:
a) d'encourager et d'aider les activités de la Fédération Nationale des Eclaireurs et Eclaireuses du Luxembourg (FNEL),
et de tout mouvement scout et guide qui viendrait à lui succéder;
b) d'appuyer le guidisme et le scoutisme et, d'une manière générale, toutes les activités organisées en faveur des jeunes;
c) d'assurer en tout ou en partie, le financement, la réalisation et la gestion de projets d'investissement, y compris le
coût d'études préparatoires, au profit de la FNEL, dans le but de fournir à celle-ci les moyens et les infrastructures
nécessaires pour lui permettre d'organiser ses activités dans un cadre approprié;
128478
L
U X E M B O U R G
d) de réaliser et de soutenir des projets d'éducation des jeunes et de formation des responsables d'unités de jeunes,
le tout dans le respect de la Nature, des principes établis par Baden-Powell, et dans un esprit de fraternité et de solidarité,
sans distinction de race, de classe et de confession.
Chapitre III. Patrimoine
Art. 3.
A) Lors de la constitution de la Fondation en date du 2 décembre 1993, l'association fondatrice dénommée Amicale
des Anciens Eclaireurs et Eclaireuses de la FNEL, Asbl, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro
F 443, avait apporté à la Fondation une somme de six cent mille francs luxembourgeois (600.000.- frs.lux.) ainsi que le
droit de superficie portant sur la propriété domaniale dénommée "Ferme Misère", inscrite au cadastre de la commune
de Rambrouch, ancienne commune d'Arsdorf, section A, lieu dit "In Ell", comme suit:
a) no 1138/1570 sartable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42,50 ares
b) no 1139/5177 pré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446,90 ares
c) no 1187/4357 maison-place . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29,70 ares
labours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180,00 ares
soit une superficie totale de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 699,10 ares
Le droit de superficie a fait l'objet d'une convention entre l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg et l'association
fondatrice en date du 29 octobre 1993. Le droit de superficie viendra à expiration, sous réserve de renouvellement, en
date du 28 octobre 2018.
B) en date du 30 décembre 2011, l'Amicale des Anciens Eclaireurs et Eclaireuses de la FNEL, asbl, en liquidation, a par
acte reçu par le notaire Joëlle Baden de résidence à Luxembourg et dans le cadre de sa dissolution et liquidation, transféré
à la Fondation la propriété des biens suivants:
a) un terrain avec immeuble bâti sis à L-6246 Rippig, 20, Grentebierg, inscrit au cadastre de la commune de Bech,
section D de Rippig comme suit:
- numéro 128/1176, place (occupée) bâtiment à habitation, lieu-dit «Grentebierg», contenant 41 ares et 40 centiares;
- numéro 131/80, terre labourable, lieu-dit «Auf dem Grunten», contenant 12 ares et 20 centiares.
b) la somme de 30.000 EUR.
C) en date de ce jour, l'Association des Girl Guides Luxembourgeoises - Guiden a Scouten asbl (en abrégé l'AGGL),
en liquidation, a par acte reçu par le notaire Joëlle Baden, prénommée et dans le cadre de sa dissolution et liquidation,
transféré à la Fondation la propriété des immeubles bâtis et non bâtis suivants:
a) les terrains et immeubles sis au numéro 61 et 61a, rue de Trèves, L-2630 Luxembourg, inscrits au cadastre de la
commune de Luxembourg, section HaA de Hamm, sous le numéro cadastral 172/6150, lieu-dit «rue de Trèves», place
(occupée) bâtiment à habitation, contenant 90 ares 99 centiares et sous le numéro cadastral 172/6264, même lieu-dit,
place, contenant 25 ares 95 centiares,
b) un terrain avec immeuble bâti sis à Colpach, inscrit au cadastre de la commune de Ell, section D de Colpach-Bas,
sous le numéro cadastral 170/821, lieu-dit «Reschweiher», place (occupée) construction légère, garage, pré et bois, d’une
contenance de 89 ares 00 centiares.
D) La Fondation peut en outre accepter des dons et des legs dans les conditions prévues par l'article 36 de la loi du
21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, telle que modifiée.
Le patrimoine se compose en outre des revenus du patrimoine de la Fondation et des revenus produits par les activités
de la Fondation.
Chapitre IV. Administration
Art. 4. La Fondation est administrée et représentée dans toutes les relations civiles et administratives par un conseil
d'administration composé au minimum de six et au maximum de treize membres.
Art. 5.
1) Le Président National (ou son délégué) et le Commissaire Général (ou son délégué) de la Fédération Nationale des
Eclaireurs et Eclaireuses du Luxembourg (FNEL) sont d'office membres du conseil d'administration. Les délégués sont à
désigner avant le début de chaque exercice.
2) Au moins deux administrateurs sont nommés sur des propositions de candidatures faites par l'Amicale AGGL asbl,
à la majorité absolue par les membres du conseil d'administration en fonction, étant entendu que l'administrateur dont
le mandat expire ne peut pas participer à la nomination qui le concerne.
3) Les autres administrateurs sont nommés sur des propositions de candidatures faites par le Comité de Direction de
la FNEL à la majorité absolue par les membres du conseil d'administration en fonction, étant entendu que l'administrateur
dont le mandat expire ne peut pas participer à la nomination qui le concerne.
4) La durée du mandat d'administrateur est de trois ans au maximum. Les mandats sont renouvelables deux fois. Les
mandats d’administrateur de personnes ayant siégé au sein du conseil d’administration antérieurement au présent chan-
gement des statuts ne sont pas pris en compte au titre de la limite de renouvellement. En cas d'expiration d'un mandat,
128479
L
U X E M B O U R G
de démission, de révocation ou de décès d'un administrateur, il sera pourvu, selon le cas, soit à un renouvellement, soit
à un remplacement. Lorsqu'il est procédé au remplacement d'un administrateur dont le mandat n'est pas expiré, le
remplaçant achève le mandat de son prédécesseur. Le conseil d'administration peut révoquer ad nutum un administrateur
coopté à la majorité simple des voix de ses membres en fonction.
5) Les charges au sein du conseil d'administration sont honorifiques et ne donnent droit à aucune rémunération.
Toutefois, les frais causés dans l'intérêt de la Fondation sont respectivement remboursés ou avancés aux intéressés sur
justification écrite à comptabiliser.
Art. 6. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et un vice-président. Le conseil d'administration
élit en outre parmi ses membres un secrétaire et un trésorier. Les fonctions de Commissaire Général de la FNEL et de
son délégué sont incompatibles avec la fonction de président du conseil d’administration.
Les séances du conseil sont présidées par le président ou le vice-président, et, en leur absence, par l'administrateur le
plus âgé.
Le secrétaire est chargé de la correspondance et de la rédaction des procès-verbaux des séances du conseil.
Le trésorier est chargé de la tenue des livres de comptabilité et il en rend compte au conseil. A la fin de chaque exercice,
le trésorier présente les comptes et le bilan au conseil qui les arrête pour être communiqués au Gouvernement.
Art. 7. Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que les intérêts de la Fondation l'exigent, et au moins tous
les six mois, au siège de la Fondation. Les avis de convocation sont signés par le président, et, en son absence, par le
secrétaire.
Art. 8. Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou
représentée. Un administrateur absent peut donner, même par correspondance (lettre, téléfax ou courrier électronique)
mandat à un de ses collègues pour le représenter aux délibérations du conseil, un même membre ne pouvant représenter
qu'un seul de ses collègues absents. Chaque mandat n'est valable que pour une seule séance.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix de
celui qui préside la réunion est prépondérante.
Les procès-verbaux des séances sont signés par celui qui préside la séance.
Les copies ou extraits des procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont certifiés conformes par le président
ou par deux administrateurs.
Art. 9. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour l'administration de la Fondation et
pour l'accomplissement de tous les actes qui tendent à la réalisation de son objet, y compris tous les actes de disposition
et notamment la vente et l'achat d'immeubles, la mainlevée d'une inscription hypothécaire ou autre et la renonciation au
privilège du vendeur et à l'action résolutoire.
Il dresse ou modifie le programme des dépenses de la Fondation, décide toutes subventions, en détermine les béné-
ficiaires et en arrête les modalités d'octroi et de contrôle d'affectation.
Il décide souverainement du placement et de la disposition de tous capitaux, de l'emploi des revenus, de la création
de fonds de réserve ou de prévision, ainsi que de tous reports d'un exercice à l'autre.
Il peut accepter des donations et des legs faits à la Fondation, sous réserve de l'approbation prévue à l'article 36 de la
prédite loi du 21 avril 1928.
Les pouvoirs du conseil d'administration énumérés ci-dessus sont énonciatifs et non pas limitatifs.
Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs pour une affaire déterminée soit à un de ses membres,
soit à un tiers.
Sauf le cas de délégation prévu à l'alinéa qui précède, tous les actes doivent, pour engager la Fondation, être signés par
deux administrateurs qui n'auront pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une délibération préalable du conseil.
Chapitre V. Comptes annuels
Art. 11. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
La gestion financière fera l'objet d'une comptabilité régulière.
Dans les deux mois qui suivent la clôture d'un exercice, le conseil d'administration établit les comptes de l'exercice
clos et le budget de l'exercice subséquent.
Dans le même délai, lesdits comptes et le budget sont communiqués au Ministre de la Justice et publiés au Mémorial,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations, conformément à l'article 34 de la prédite loi du 21 avril 1928.
Chapitre VI. Modification des statuts
Art. 12. Les statuts peuvent être modifiés par une résolution du conseil d'administration qui aura subi l'épreuve du
second vote. Il y aura entre les deux délibérations un intervalle d'au moins un mois, mais n'excédant pas trois mois.
Cette résolution sera prise à la majorité des trois-quarts des membres du conseil; les membres composant cette
majorité devront tous être présents ou représentés aux réunions appelées à statuer sur les modifications aux statuts.
128480
L
U X E M B O U R G
Les modifications aux statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir obtenu l'accord du Ministre de la Justice.
Il ne pourra jamais être porté atteinte à l'objet de la Fondation, ni à son caractère de neutralité raciale, sociale, politique
et religieuse.
Chapitre VII. Dissolution
Art. 13. En cas de disparition de la Fondation par dissolution ou liquidation ou de toute autre façon, la totalité du
patrimoine de la Fondation, à l'exception du droit de superficie repris en l'article 3 A, sera transmise à une fondation de
droit luxembourgeois ou à une association sans but lucratif reconnue d’utilité publique par arrêté grand-ducal sinon à une
association sans but lucratif de droit luxembourgeois ou fédération d’associations sans but lucratif de droit luxembour-
geois dont l'objet est de promouvoir le mouvement guide et scout.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par nom, prénom
usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. MATAGNE, R. LOOS et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 4 mars 2014. LAC / 2014 / 9903. Reçu douze euros € 12,-
<i>Le Receveuri>
(signé): THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.
Modification des statuts suivant approbation par arrêté Grand-Ducal reçu par le Ministère de la Justice en date du 18
juillet 2014.
Luxembourg, le 18 mars 2014.
Référence de publication: 2014117263/167.
(140134308) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2014.
Mangrove IV (SCA), SICAR, Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 188.960.
STATUTES
In the year two thousand and fourteen, on the twenty-third day of July.
Before us Maître Edouard Delosch, notary residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg.
There Appeared:
1. Mangrove IV Partners SCSp, a société en commandite spéciale formed under the laws of Luxembourg, with registered
office at 31, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
here represented by Madia Camara, maître en droit, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy,
2. Mangrove Equity Partners SCSp, a société en commandite spéciale formed under the laws of Luxembourg, with
registered office at 31, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
here represented by Madia Camara, maître en droit, professionallyresiding in Luxembourg, by virtue of a proxy, and
3. Mangrove IV GP S.à r.l., a société à responsabilité limitée, duly incorporated under the laws of Luxembourg, with
registered office at 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2355 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, having a share
capital of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500) and in the process of being registered with the Luxembourg
Trade and Companies’ Register,
here represented by Madia Camara, maître en droit, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy.
The said proxies, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary, shall remain annexed
to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing parties have requested the officiating notary to enact the deed of incorporation of a partnership limited
by shares (société en commandite par actions) which they wish to incorporate with the following articles of association:
Title I. Definitions - Denomination and Form - Duration - Purpose - Registered office
Art. 1. Definitions. All terms not expressly defined in the present articles of association (the “Articles“) shall have the
meaning ascribed to them in the private placement memorandum (the “Placement Memorandum”) as established by the
Fund (as defined below) as required and within the meaning of the Luxembourg law of 15 June 2004 on the investment
company in risk capital, as amended (the “2004 Law”) as such Placement Memorandum may be amended in accordance
with its terms from time to time.
Art. 2. Denomination, Form and Manager. There is hereby established between Mangrove IV GP S.à r.l., acting as
founding general partner (the “General Partner”) and the founding limited partner and all those who may become owners
of the Shares to be issued in accordance with these Articles, a corporate partnership limited by shares (société en
128481
L
U X E M B O U R G
commandite par actions) qualifying as an investment company in risk capital (société d'investissement en capital à risque)
under the name of “MANGROVE IV (SCA), SICAR”, which will be governed by the Luxembourg law dated 10 August
1915 on commercial companies, as amended (the “1915 Law“), the 2004 Law, the present Articles as well as the Placement
Memorandum (the “Fund“). The Fund qualifies as an alternative investment fund as per the law of 12 July 2013 on alter-
native investment fund managers (the “AIFM Law”).
The General Partner has appointed Mangrove Capital Partners S.A. as manager (gérant) and alternative investment
fund manager (gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs - AIFM) of the Fund (the “Manager”). All powers not
expressly vested in the General Partner or the General Meeting shall thus be vested in the Manager.
All documents drafted by the Fund and addressed to third parties, such as letters, invoices or publications, must bear
the registered name of the Fund followed by “société en commandite par actions sous forme de société d’investissement
en capital à risque”, the address of the registered office of the Fund and the initials R.C.S Luxembourg, followed by the
number under which the Fund is registered with the Luxembourg trade and companies register.
Art. 3. Duration. The Fund is constituted for a ten (10) year period as of the Initial Closing Date.
The term of the Fund may be extended by two (2) additional one (1) year periods upon a Special Resolution of the
General Meeting (as defined in article 24).
Art. 4. Purpose. The purpose of the Fund is to invest its assets in securities and other assets representing risk capital
within the broadest possible meaning permitted under article 1 of the 2004 Law and CSSF Circular 06/241 in order to
provide its shareholders with the benefit of the result of the management of its assets in consideration of the risk they
incur in this respect subject always to the terms of the Placement Memorandum.
The investment objectives and strategy for the Fund are more fully described in the Placement Memorandum.
The Fund may in general invest directly or indirectly in any debt, equity or other interests (including publicly traded
securities thereof) to the extent such investments represent risk capital investments, each time in accordance with the
2004 Law and CSSF circulars issued from time to time, including for the avoidance of doubt, the CSSF Circular 06/241,
and are eligible under the Placement Memorandum.
The Manager will manage the Fund’s investments with a view to developing and adding value to the investments of the
Fund and in accordance with the Placement Memorandum.
The Fund may also enter into, assist or participate in any financial, commercial and other transactions, and in particular,
without limitation, grant to any corporate body, association, partnership or other entity or person wherever established,
incorporated or resident, in which the Fund proposes to make or holds, directly or indirectly, an investment, or any other
company associated in any way with the Fund, in which the Fund has a direct or indirect financial interest, any assistance,
loans, advances or guarantees; borrow and raise money in any manner and secure the repayment of any money borrowed;
in particular, the Fund may borrow money from third parties or from its shareholders for the funding, completion,
refinancing of an investment, or to cover any of its expenses subject always to the terms of the Placement Memorandum.
The Fund may execute, deliver and perform all contracts and other obligations and engage in all activities and trans-
actions as may in the opinion of the Manager be necessary or advisable in order to carry out the foregoing purposes and
objectives, subject to and in accordance with the provisions of the Placement Memorandum.
Art. 5. Registered Office. The Fund has its registered office in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
The registered office may be transferred within the municipality of the city of Luxembourg by a resolution of the
Manager. The CSSF will be informed in advance of such transfer.
The registered office of the Fund may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means
of a resolution of a General Meeting deliberating by way of a Special Resolution.
Should any political, economic or social events of an exceptional nature occur or threaten to occur that are likely to
affect the normal functioning of the registered office or communications with foreign countries, the registered office may
be provisionally transferred to a foreign country until such time as circumstances have completely returned to normal.
Such decision will not affect the nationality of the Fund which will, notwithstanding such transfer, remain a Luxembourg
company. The decision as to the transfer of the registered office to another country will be made by the Manager.
The Fund may have other offices and branches in Luxembourg and subsidiaries either in Luxembourg or abroad.
Title II. Capital - Shares - Shareholders
Art. 6. Share Capital and Conversion. The Fund has a fixed share capital of fifty thousand euros (€ 50,000) divided into
(i) two thousand (2,000) class B shares, each having a nominal value of one euro cent (€ 0.01) (the “Class B Shares”) and
(ii) one management share with a nominal value of forty-nine thousand nine hundred eighty euros (€ 49,980) (the “Ma-
nagement Share”).
The Manager is authorised to issue up to two million five hundred thousand (2,500,000) Class A Shares at a nominal
value and subscription price of one euro cent (€ 0.01) each (the “Class A Shares”) without offering to the existing
shareholders any preferential subscription each time in accordance with the terms and conditions of the Placement
Memorandum. The Manager is furthermore authorised to accept additional capital contributions without the issuance of
additional Shares, each time within the terms and conditions of the Placement Memorandum.
128482
L
U X E M B O U R G
Subject to the above, the Manager may further issue a special class of tracking shares (the “Class E Shares” and together
with the Class A Shares, Class B Shares and the Management Share, the “Shares”), which shall either be newly issued or
issued via the conversion of a corresponding number of Class A Shares in respect of and in order to track the economic
entitlements pertaining to a specific Excluded Investment only as described in further detail in the Placement Memoran-
dum. For each Excluded Investment, the Manager will thus issue a separate and dedicated Sub-Class (e.g., Class E1, Class
E2, etc.).
All the Shares are issued as fully redeemable Shares as provided for in article 49-8 of the 1915 Law provided that any
redemption of Shares must be made in accordance with the terms of the Placement Memorandum and these Articles.
The minimum capital of the Fund including any issue premiums and capital contributions, which must be achieved within
twelve (12) months after the date on which the Fund has been authorized as a société d’investissement en capital à risque
(SICAR) under Luxembourg law, is one million euros (€ 1,000,000).
Art. 7. Issuance of Shares. The Fund will issue two (2) classes of shares (each referred to as a “Class”), Class A Shares
and Class B Shares, in exchange for contributions in cash to the capital of the Fund. Under certain circumstances, Class
E Shares may be issued either in exchange for contributions in cash or in kind to the capital of the Fund or by conversion
of the corresponding number of Class A Shares, whereby one (1) Class A Share may be converted into one (1) Class E
Share or a Sub-Class thereof.
Other conditions linked to the issuance of Shares are further described in the Placement Memorandum.
Art. 8. Well-Informed Investors. The ownership of Shares is restricted to “Well-Informed Investors” within the mean-
ing of article 2 of the 2004 Law. Any marketing of Shares outside of Luxembourg shall be subject to any applicable local
law rules and regulations, as the case may be.
Art. 9. Form of Shares/Register of shareholders. Shares will be issued in registered form only.
All issued Shares of the Fund shall be registered in the register of shareholders, which shall be kept by the Registrar
Agent. Such register shall contain the name, residence and address of each shareholder, the number and class of Shares
held by it and, if applicable, their date of transfer. Transfers of ownership will become effective only after its entry in the
register of shareholders.
The registration of the shareholder’s name in the register of shareholders evidences its right of ownership over such
registered Shares. Each shareholder shall receive a written confirmation of its shareholding. Certificates representing the
Shares will only be issued upon request of the shareholder at the requesting shareholder’s expense and shall be signed
by the Manager.
A shareholder may, at any time, change its address as entered in the register of shareholders by means of a written
notification to the Fund at its registered office, or at such other address as may be set by the Fund from time to time.
The Shares are indivisible with regard to the Fund, which admits only one owner per Share.
Fractional Shares may be issued up to three decimal places and shall carry rights in proportion to the fraction of a
Share they represent but shall carry no voting rights except to the extent that their number is so that they represent a
whole Share in which case they confer a voting right.
Art. 10. Transfer and ownership of Shares. Class A Shares, Class E Shares and Class B Shares may only be sold, assigned
or transferred in accordance with the Placement Memorandum. Any transfer or assignment of Class A Shares, Class E
Shares and Class B Shares is subject to the transferee or assignee thereof fully and completely assuming in writing, prior
to the transfer or assignment, all outstanding obligations of the transferor or assignor under any commitment agreement
entered into by such transferor or assignor and must qualify as a wellinformed investor pursuant to article 2 of the 2004
Law.
The Manager shall have the power to impose such restrictions (other than any restrictions on the transfer of Shares)
as it may think necessary for the purpose notably of ensuring that no Shares in the Fund are acquired or held by any
person, firm or corporate body (i) in breach of the laws and requirements of any country or governmental authority
(including Luxembourg) or (ii) in circumstances which in the opinion of the Manager might result in the Fund incurring
any liability to taxation or suffering any pecuniary disadvantage which the Fund might not otherwise have incurred or
suffered.
For that purpose the Manager may:
a) decline to issue any Share and decline to register any transfer of a Share where it appears to it that such registration
of action or transfer would or might result in legal or beneficial ownership of such Share being held by a person who is
precluded from holding Shares of the Fund;
b) at any time require any person whose name is entered in the register of shareholders to furnish it with any infor-
mation, supported by affidavit, if need be, which it may consider necessary for the purpose of determining whether or
not legal or beneficial ownership of such shareholder's Shares rests or will rest in a person who is precluded from holding
Shares of the Fund; and
c) where it appears to the Fund that any person, who is precluded from holding Shares of the Fund is a legal or beneficial
owner of Shares or holds Shares, cause the Fund compulsorily to repurchase from any such shareholder all Shares held
by such shareholder in the manner specified in article 11 of these Articles.
128483
L
U X E M B O U R G
Art. 11. Redemption of Shares. The Fund will not, at the request of a shareholder, redeem its Shares.
The Fund however may redeem Shares as provided in the Placement Documents and including notably in the following
cases:
(i) Redemption for the purposes of distributing proceeds pursuant to the Placement Memorandum;
(ii) Compulsory redemption of Shares held by a defaulting investor pursuant to the Placement Memorandum;
(iii) Redemption of Shares held by a Prohibited Person as described in the Placement Memorandum;
(iv) Redemption of Shares for purposes of ensuring compliance with Section 1471 through 1474 of the Code and any
guidance issued thereunder, including any applicable intergovernmental agreement and any local laws with respect thereto
(“FATCA”); or
(v) Redemption in case of removal of the General Partner pursuant to the Placement Memorandum.
In any event, a redemption cannot be made if, as a result, the Net Asset Value of the Fund would fall below one million
euros (€ 1,000,000).
In addition thereto, Class A Shares, Class E Shares and Class B Shares shall be redeemed compulsorily if a transfer of
Shares has been made in breach of the Articles or, with respect to Class A Shares and Class E Shares, if the relevant
Investors cease to be or are found not to be Well-Informed Investors or otherwise qualify as Prohibited Person. The
redemption price per Share in case of compulsory redemption will be equal to the subscription price paid per Share
(excluding any Actualization Interest but including Special Premium Contributions, if any) plus the relevant Investor’s
share in the special equity reserve account (SPERA) contributions at such time multiplied by the discount rate stated in
the Placement Memorandum, which is a function of the level of drawdowns reached at the time of occurrence of a
compulsory redemption event, in accordance with the Placement Memorandum.
Notwithstanding anything to the contrary in the Placement Memorandum, should a Class A Investor or Class E Investor
lose its status of Well-Informed Investor as a result of its death or after having been adjudicated incompetent or insane,
the compulsory redemption price for the Class A Shares and Class E Shares shall be equal to the latest available Net
Asset Value (as defined below) per Share reduced by any costs and/or expenses incurred by the Fund as a result thereof.
Payment shall however be made by the Fund at a date to be determined by the Manager at its sole discretion but, in any
case, no later than upon the final liquidation payment upon dissolution of the Fund. Any such redemption amount shall
not bear interest.
The Shares so redeemed will only be cancelled and the capital reduced accordingly upon a decision of the General
Meeting adopted via a Special Resolution (as defined below).
Art. 12. Defaulting Investor provisions. In the event that an investor fails to pay to the Fund the portion of its com-
mitment specified in a drawdown notice on or before the date specified therein for such payment to be made (the
“Drawdown Date”), the amount outstanding shall bear interest equal to 6-month Euribor interest rate, as published as
at 11:00 a.m. (London time) on the relevant Drawdown Date by Reuters, plus 300 basis points for the period from the
Drawdown Date until the date on which such outstanding amount and interest thereon shall have been paid in full (the
“Cure Date”).
In such a case, further calls may be made upon the other Investors of the same Class as that of the relevant Investor
(up to but not exceeding their respective undrawn Commitments and pro rata to their respective Commitments) in
order to make good the shortfall.
If the relevant Investor fails to pay in full the outstanding amount and interest accrued thereon, on or before the tenth
(10
th
) Business Day following the Drawdown Date (the “Cure Period”), the Manager shall, without further notice,
declare this a “Default Event” and the relevant Investor a “Defaulting Investor” and the Defaulting Investor will immediately
lose any right to be represented on the Investor Advisory Committee and the Defaulting Investor shall abstain from
exercising its voting rights attached to the Defaulting Investor’s Shares and the Manager, acting in the best interest of the
Fund, will have the obligation to exercise the remedies set out below within a maximum period of thirty (30) calendar
days as from the end of the Cure Period.
In addition, from the relevant Drawdown Date until the relevant Cure Date:
i the Defaulting Investor shall abstain from participating in any vote, consent or decision of the Fund, and such vote,
consent or decision, will be given or made as if such Defaulting Investor were not an Investor and such Investor’s drawn
and undrawn Commitments will be disregarded for the purposes of any vote, consent or decision required; and
ii such person’s right to participate in, or vote at, any meeting of the Investor Advisory Committee (through a repre-
sentative as the case may be) shall be suspended.
In addition, the Manager may bring any legal action against the Defaulting Investor as it reasonably determines is in the
best interest of the Fund.
- First, compulsory redemption of the Shares of Defaulting Investors
All Shares registered in the name of the Defaulting Investor that are fully paid are subject to a compulsory redemption
by the Fund (the “Default Redeemable Shares”) in accordance with the following rules and procedure:
i. after the expiration of the Cure Period, the Manager will send a notice (hereinafter called the “Redemption Notice”)
to the Defaulting Investor; the Redemption Notice shall specify the Default Redeemable Shares to be redeemed, the price
128484
L
U X E M B O U R G
to be paid, and the date and place where the redemption price shall be payable. The Redemption Notice may be sent to
the Defaulting Investor by registered mail to its last known address. From the close of business of the day specified in
the Redemption Notice, the Defaulting Investor shall cease to be the owner of the Default Redeemable Shares; and
ii. the redemption price per Share (the “Default Redemption Price”) will be equal to the lower of (i) the subscription
price per Class A Share or Class E Share paid (excluding any Actualization Interest but including Special Premium Con-
tributions, if any) upon subscription at the time for the Default Redeemable Shares PLUS the Defaulting Investor’s share
in the SPERA contributions (as defined in the Placement Memorandum) at such time multiplied by the discount rate stated
below (the “Discount Rate”) and (ii) the distributed-topaid-in value, being the cumulative distributions returned to In-
vestors as a proportion of the paid-in capital (“DPIV”), per Class A Share and as applicable Class E Share as assessed at
the close of the liquidation of the Fund multiplied by the Discount Rate. The abovementioned Default Redemption Price
will be finally determined and payable only at the close of the liquidation of the Fund.
The Discount Rate applied is a function of the level of drawdowns reached at the time of occurrence of a Default
Event and will be as follows:
1. in % of Aggregate
Drawn Down
1
Disco unt Rate in %
0-10
100
11-20
95
21-30
90
31-40
85
41-50
75
51-60
65
61-70
50
71-80
30
81-90
10
91-100
5
Commitments
- Then, potential transfer of the Shares of the Defaulting Investor
After and in addition to the compulsory redemption mechanism foreseen above, the Manager will offer the previously
redeemed Default Redeemable Shares (in accordance with the above procedure) to the other non-defaulting Investors,
and, in case not all the Default Redeemable Shares are taken up by the other Investors, to third party transferees (excluding
Manager Related Persons and Manager Related Entities (both as defined in the Placement Memorandum). The sale process
shall be brought to completion in accordance with the following procedure:
i. The Manager shall send a written notice of the default to the non-defaulting Investors (each a “Non-Defaulting
Investor”) within five (5) Business Days from the redemption under (i) above becoming effective, together with the number
of Shares that are offered to each relevant Non-Defaulting Investor and the offer price of those shares, and each Non-
Defaulting Investor shall then confirm in writing, by registered mail or facsimile to the Manager, within fourteen (14)
Business Days following the date of the notification received from the Drawn Down1 Disco unt Rate in % 0-10 100 11-20
95 21-30 90 31-40 85 41-50 75 51-60 65 61-70 50 71-80 30 81-90 10 91-100 5 Manager, their acceptance, or that they
decline to purchase such number of Shares at such price as indicated in the relevant acceptance confirmation.
ii. The sale shall be completed and reflected as such by the Manager in the register of Investors of the Fund, in proportion
to the number of Shares held by each of the Investors (including the General Partner) confirming their acceptance to
purchase the Shares from the Fund, it being agreed and understood that by not confirming its (their) acceptance of the
purchase, the relevant Investor(s) or General Partner increase(s) the other Investors’ rights for the proportion of Shares
which will not be acquired by such Investors.
iii. The Investors and the General Partner each agree that their acceptance to purchase such number of Shares as
indicated in the acceptance confirmation shall necessarily imply that the relevant parties or assignee thereof automatically
and irrevocably fully and completely assume their pro rata share of the undrawn Commitments of the Defaulting Investor
that remain outstanding towards the Fund on the relevant transfer date and the transfer of the Shares to the relevant
Investors will also automatically result in a transfer of the relevant pro rata rights attached to the SPERA relating to those
Shares.
iv. The rights of any Default Redeemable Shares so acquired shall be reinstated and the proceeds derived from the
above process, less any transaction cost incurred by the Fund, shall be transferred by the Fund to the Defaulting Investor.
v. Any previously redeemed Default Redeemable Shares, which shall not be transferred in accordance with the above
procedure, shall be cancelled by the Fund.
Title III. Valuation
Art. 13. Calculation of the Net Asset Value. The net asset value (“Net Asset Value”) of the Fund will be determined
by the administrative agent in accordance with Lux GAAP and in euros, which shall be the Reference Currency of the
Fund, under the responsibility of the Manager as of the last Business Day of each calendar quarter (a "Valuation Date")
starting with the calendar quarter ending on or following the Initial Closing as foreseen in the Placement Memorandum.
128485
L
U X E M B O U R G
The Net Asset Value of the Fund is equal to the difference between the value of its gross assets and its liabilities.
The value of the assets of Fund based on their fair value will be determined as follows:
a) the value of any cash on hand or on deposit, bills and demand notes and accounts receivable, prepaid expenses, cash
dividends and interest declared or accrued as aforesaid, and not yet received shall be deemed to be the full amount
thereof, unless it is unlikely to be received in which case the value thereof shall be arrived at after making such discount
as the Manager may consider appropriate in such case to reflect the true value thereof;
b) any transferable security and any money market instrument negotiated or listed on a stock exchange or any other
organized market will be valued on the basis of the last known price, unless this price is not representative, in which case
the value of such asset will be determined on the basis of its fair value;
c) investments in private equity securities and in any Portfolio Company will be valued by the Manager in accordance
with the International Private Equity & Venture Capital (IPEV) Valuation Guidelines as endorsed by the European Private
Equity and Venture Capital Association (EVCA), as may be amended from time to time, provided that if EVCA recom-
mends the use of other valuation principles, then these principles shall be adopted by the Fund and applied consistently;
d) the value of all portfolio securities and money market instruments or derivatives that are listed on an official stock
exchange or traded on any other regulated market will be based on the last available price on the principal market on
which such securities, money market instruments or derivatives are traded, as supplied by a recognized pricing service
approved by the Manager. If such prices are not representative of the fair value, such securities, money market instruments
or derivatives as well as other permitted assets may be valued at a fair value at which it is expected that they may be
resold, as determined in good faith by and under the direction of the Manager;
e) the valuation of derivatives traded over-the-counter (OTC), such as futures, forward or option contracts not traded
on exchanges or on other recognized markets, will be based on their net liquidating value determined, pursuant to the
policies established by the Manager on the basis of recognized financial models in the market and in a consistent manner
for each category of contracts. The net liquidating value of a derivative position is to be understood as being equal to the
net unrealized profit/loss with respect to the relevant position. The Fund shall only enter into derivatives traded OTC in
connection with hedging activities; and
f) the value of any other assets of the Fund will be determined on the basis of the acquisition price thereof including
all costs, fees and expenses connected with such acquisition or if such acquisition price is not representative, the value
of any other assets of the Fund will be determined on the basis of their fair value.
The Net Asset Value per Class as of any Valuation Date will be made available to Investors within sixty (60) calendar
days following the relevant Valuation Date.
Art. 14. Temporary Suspension of the Calculation of the Net Asset Value. The Manager may suspend the determination
of the Net Asset Value during:
a) the existence of any state of affairs which constitutes an emergency as a result of which disposals or accurate valuation
of a substantial portion of the assets owned by the Fund would be impracticable;
b) any breakdown occurs in the means of information normally employed in determining the price or value of any of
the investments or current stock exchange or market price; or
c) any period when any of the principal stock exchanges or markets, on which any substantial portion of the investment
of the Fund are quoted or dealt in, is closed otherwise than for ordinary holidays, or during which dealings therein are
restricted or suspended.
Shareholders will be informed of any such suspension if, in the opinion of the Manager, it is likely to exceed eight (8)
business days.
Title IV. Management - Representation
Art. 15. Management. Mangrove IV GP S.à r.l. is and shall remain the general partner (associé-commandité) (the "Ge-
neral Partner") for the duration of the Fund, unless removed in accordance with article 22 of these Articles and the
Placement Memorandum. The General Partner has conveyed upon the Manager the broadest powers to manage and
administer the Fund in accordance with the 1915 Law, the SICAR Law and the AIFM Law.
The shareholders may not participate or interfere in the management of the Fund and shall have no right or authority
to act on behalf of the Fund in any manner or capacity other than by exercising their rights as shareholders in General
Meetings.
The Manager takes all investment and divestment decisions through a unanimous vote of its governing body. The board
of directors of the Manager carries out all investment management, administration and marketing functions relating to
the Fund (i.e., for the avoidance of doubt all core and ancillary functions as defined in Annex 1 of the AIFM Law). It may
delegate certain functions to related or unrelated third party service providers, subject to the terms of the Placement
Memorandum. In case of related third party service providers, the Manager will ensure that an appropriate mechanism
for the avoidance and resolution of conflicts of interest is applied in accordance with the Placement Memorandum.
Art. 16. Liability. The General Partner is liable with the Fund for all liabilities which cannot be satisfied out of the assets
of the Fund. Shareholders shall be liable only to the extent of their commitment to the Fund.
128486
L
U X E M B O U R G
Art. 17. Authority - Powers. Unless otherwise provided by the 1915 Law, these Articles or the Placement Memoran-
dum, the Manager is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Fund’s
interest which are not expressly reserved by the 1915 Law, these Articles or the Placement Memorandum to the General
Meeting.
The Manager shall namely have the power, on behalf and in the name of the Fund, to carry out and implement any and
all of the purposes of the Fund and to perform all acts and enter into and perform all contracts and other undertakings
that it may deem necessary or advisable or incidental thereto. Except as otherwise expressly provided for herein or in
the Placement Memorandum, the Manager shall have full authority and discretion to exercise, on behalf of and in the
name of the Fund, all rights and powers necessary or required to realize the purpose of the Fund.
In particular and to the full extent permitted under the 1915 Law, the Manager shall have full power and authority, on
behalf of the Fund, to do all such things as are, in the reasonable opinion of the Manager, necessary or desirable in
connection with the operation of the Fund, the management of the Fund’s investments or otherwise in the furtherance
of the Fund’s business as more fully described in the Placement Memorandum.
For the avoidance of doubt and as set forth in the Placement Memorandum, the Manager is entitled to create and
establish any committee and to appoint any advisor to provide it with knowledge, insight and recommendations in con-
nection with the performance of its duties for and on behalf of the Fund.
Art. 18. Representation. The Fund shall be bound by the sole signature of the Manager, its legal representatives or
such other person(s) to which the Manager has delegated such power.
Art. 19. Delegation of Power. The Manager may from time to time and under its responsibility delegate its powers to
perform specific tasks to one or more ad hoc agent(s).
The Manager will determine the powers, duties and remuneration of these agents and/or committees, the duration of
their appointment and any other relevant conditions to their appointment each time in accordance with the provisions
foreseen in the Placement Memorandum.
Art. 20. Conflicts of Interest. The Fund is organized and structured in such a way so as to minimize potential conflicts
of interest in accordance with article 7bis of the 2004 Law.
The General Partner, the Manager, the Depositary, the Administrative Agent and their respective affiliates, directors,
officers, shareholders, are or may be involved in other financial, investment and professional activities which may cause
conflicts of interest with the management and administration of the Fund. These include the management of other col-
lective investment schemes, purchase and sale of securities, brokerage services, custody and safekeeping services and
serving as directors, officers, advisors, distributors or agents of other collective investment schemes or other companies.
Subject to the terms of the Placement Documents should the Manager or the General Partner become aware of a
conflict of interest in a contemplated transaction, the Manager or General Partner shall (i) refer such conflict to the
Investor Advisory Committee which shall review and take position (i.e. approve or reject the relevant transaction or
arrangement giving rise to the (actual or potential) conflict of interest) on such conflicts of interest, applying arm's length
principles and (ii) in accordance with article 57 of the 1915 Law, report such conflict to the next succeeding General
Meeting.
The Investor Advisory Committee shall consider the relevant conflict issue according to such process and within such
period as set forth in the Placement Memorandum, save for any matter designated as urgent, in which case the Investor
Advisory Committee shall promptly be convened in order to address the relevant conflict (being acknowledged that the
prior notice for an Investor Advisory Committee meeting cannot be less than forty-eight (48) hours). The Manager shall
fully cooperate with the Investor Advisory Committee and make available all such further information as the Investor
Advisory Committee may reasonably request in accordance with the Placement Documents.
The Investor Advisory Committee may request the assistance and support of any external expert, as the case may be
at the reasonable cost of the Fund.
No Investor (other than Manager Related Person and Manager Related Entities) will be required or expected to disclose
or make available to the Fund, investment opportunities it may pursue for its own account or in the capacity as share-
holder, manager or advisor of any other collective investment scheme, including investment opportunities suitable to or
under consideration by the Fund. In case of a conflict of interest, the conflicted party will refrain from voting on such
matters. In addition, potential conflicts of interest may arise from the overall activities of the Manager and its affiliates.
Art. 21. Indemnification. To the fullest extent permitted by applicable law (a) the General Partner, the Manager, any
affiliate of the General Partner or the Manager and any of their officer, director, shareholder, partner, agent, member or
employee to the extent involved in the operation and management of the Fund (each a “Manager Indemnified Person”)
and (b) each of the members of the Investor Advisory Committee and the Investors they represent and any of their
directors, officers and employees (each an “IAC Indemnified Person”) shall not be liable for any loss, liability, action, suit,
proceeding, claim, cost, demand, damage or expense (including reasonable legal fees and expenses and costs of investi-
gation) incurred or threatened (collectively, the “Claims and Expenses”) by reason of any action taken or omitted to be
taken by such Indemnified Person if such action was taken or omitted to be taken (i) in good faith and in the reasonable
belief that such action or omission was in, or was not opposed to the best interests of the Fund or (ii) in good faith in
128487
L
U X E M B O U R G
accordance with the advice of legal counsel; provided however, that the foregoing shall not relieve any (a) Manager
Indemnified Person from liability for any Claims and Expenses that resulted from acts or omissions of such Indemnified
Person which constituted gross negligence, wilful or reckless misconduct, intentional or reckless disregard of its obliga-
tions and duties in relation to the Fund, fraud, wilful and material breach of any contractual arrangements agreed upon
by or with one or more Investors, commission of a criminal offence, material breach of fiduciary duty or other material
breach of any obligations under any regulatory arrangements made or established pursuant to applicable law and to which
the Manager Indemnified Person is subject; and (b) IAC Indemnified Person from liability for any Claims and Expenses
that resulted from acts or omissions of such IAC Indemnified Person’s participating in the Investor Advisory Committee
which constituted gross negligence or fraud.
To the fullest extent permitted by applicable law, the Fund shall indemnify and hold harmless each of the Indemnified
Persons from and against any and all Claims and Expenses which may be imposed on, incurred by or asserted at any time
against any (a) Manager Indemnified Person related to or arising out of any contractual arrangements agreed upon by
Investors or the management or administration of the Fund or in connection with the business or affairs of the Fund or
the activities of such Indemnified Person on behalf of the Fund and any (b) IAC Indemnified Person in relation to acts or
omissions committed in the context of such IAC Indemnified Person’s participation in the Investor Advisory Committee;
provided however, that (a) no Manager Indemnified Person shall be entitled to indemnification hereunder to the extent
such Claims and Expenses resulted from acts or omissions of an Indemnified Person which constituted gross negligence,
wilful, reckless misconduct, intentional or reckless disregard of its obligations and duties in relation to the Fund, fraud,
wilful and material breach by the Manager of any contractual arrangements agreed upon by the relevant Investors, com-
mission of a criminal offence, material breach of fiduciary duty or other material breach of any obligations under any
regulatory arrangements made or established pursuant to applicable law and to which the Manager Indemnified Person
is subject; and (b) no IAC Indemnified Person shall be entitled to indemnification hereunder to the extent such Claims
and Expenses resulted from acts or omissions of such IAC Indemnified Person in the context of that IAC Indemnified
Person’s participating in the Investor Advisory Committee which constituted gross negligence or fraud. The Fund may
nevertheless advance legal fees payable by the Indemnified Person in connection with the defence against such claim or
action to a reputed counsel previously approved by the Manager.
Upon indemnification by the Fund, the Fund shall be subrogated in all rights of the Manager Indemnified Person or IAC
Indemnified Person to the largest extent permitted under applicable law. However, the Manager Indemnified Person or
IAC Indemnified Person shall procure that all reasonable endeavours are used to recover any amounts due under insu-
rance policies entered into for such coverage prior to exercising any of the rights such Manager Indemnified Person or
IAC Indemnified Person may have against the Fund contained herein. Insurance policies covering professional liability risks
of any Manager Indemnified Person or IAC Indemnified Person will be contracted by the Fund with an appropriate
insurance company at prevailing market conditions.
The above provisions shall give no right of indemnity to a Manager Indemnified Person or IAC Indemnified Person to
the extent that (a) the relevant Claims and Expenses are a result of a dispute with another (or former) Manager Indemnified
Person or among Manager Indemnified Persons (or former Manager Indemnified Persons), (b) indemnity amounts borne
by the Fund would exceed in aggregate the lower of (i) twenty-five (25.00) per cent of Aggregate Commitments and (ii)
unfunded Commitments plus amounts derived or to be derived from the realization of the Fund's portfolio, (c) the relevant
Claims and Expenses are incurred in the Indemnified Person’s capacity as a controlling person, officer, manager, partner,
employee or agent of any Portfolio Company of the Fund if all of the events giving rise to such Claims and Expenses occur
after the Fund has completely realized its investment in such Portfolio Company, or (d) such indemnification would
become payable at a date that is two (2) years after the close of the liquidation of the Fund.
Notwithstanding the foregoing, the indemnification shall each time be suspended where the request for indemnification
is made by an Indemnified Person that is subject to a collective shareholder action by Investors representing the majority
of the Shares issued and outstanding. Upon resolution of any such collective shareholder action, the suspension will either
be levied and the Indemnified Person will be indemnified if the action was without merits or the suspension will become
final, without prejudice to any further consequences, actions or recourse.
Art. 22. Removal of the General Partner and the Manager. The Manager has been appointed by and may only be
removed by the General Partner, provided that any removal of the Manager outside the removal of the General Partner
must be approved by Special Resolution (with Manager Related Persons or Manager Related Entities abstaining from
exercising their votes).The removal of the General Partner will ipso facto trigger the removal of the Manager.
A decision to remove the General Partner requires the approval of the General Meeting. The Manager Related Persons
or Manager Related Entities (and the Manager and the General Partner will procure that these persons) shall abstain from
casting their votes, and the General Partner will not have any veto right, in respect of such resolution and the Commit-
ments and votes of any Manager Related Person or Manager Related Entity will not be taken into account for the purpose
of any resolution taken by the General Meeting in the context of a removal for cause or without cause. For the avoidance
of doubt, for voting purposes, Class E Shares will always be assimilated to the Class A Shares.
The General Partner may not be removed and replaced by another (managing) general partner except pursuant to the
below:
128488
L
U X E M B O U R G
- The General Meeting may resolve by way of a Reinforced Majority Resolution (with Manager Related Persons or
Manager Related Entities abstaining from exercising their votes) (as defined in the Placement Memorandum) to remove
the General Partner if such Investors resolve that any of the following “Cause Events” has occurred (the date of such
resolution being the “Removal for Cause Date”): (a) any of the Manager Related Person has committed fraud, bad faith,
wilful misconduct, reckless disregard or gross negligence in connection with the performance of their/its duties to the
Fund or the Investors; (b) any of the Manager Related Person has committed a material breach of the Placement Docu-
ments, the fund management services agreement or any Side Letter or similar agreements; (c) the General Partner or
the Manager has been declared insolvent, bankrupt, or is the subject of an administration procedure or involuntary
reorganisation of its assets; (d) the withdrawal of the Fund from the official list of SICARs by the CSSF; or (e) the conviction
of any Manager Related Person for criminal acts by a court of competent jurisdiction (a “For Cause Removal”).
- The General Meeting may at any time resolve to remove the General Partner (a “Without Cause Removal”) with a
Special Resolution (for the purposes of which the Manager Related Persons and Manager Related Entities will abstain from
voting their shares and the General Partner will not have a veto right).
Upon a removal decision:
(i) in the event of a For Cause Removal,
a. On the Removal for Cause Date: the Manager shall transfer all Class B Shares to the Fund at a price equal to the
subscription price paid upon subscription including the allocated and effectively paid-in SPERA contributions until such
date less all distributions received;
b. the Manager shall be revoked as manager and alternative investment fund manager of the Fund and the fund mana-
gement services agreement will terminate with immediate effect;
c. the Investment Period (if not already terminated) will be suspended (and will only resume upon the replacement of
the General Partner);
d. the Manager Related Persons will forthwith abstain from exercising their voting rights attached to any Class A Shares
which they may hold;
e. the Manager shall no longer receive the Manager Return from the date of removal; and
f. the General Partner and the Manager shall automatically forfeit all of their rights to future distributions pursuant to
the waterfall set forth in the Placement Memorandum.
(ii) in the event of a Without Cause Removal:
a. the removed Manager shall be entitled to a lump-sum compensation equal to the four instalments of the Manager
Return paid or payable in respect of the last four quarters immediately preceding the date of the removal decision (the
“Compensation”) with the payment of such Compensation to be made once the General Partner and the Manager will
have provided the replacing general partner (and investment manager or adviser as the case may be) with all assets, books
of accounts, records, registers and other documents belonging or relating to the Fund in their possession or control and
in any event no later than one hundred and eighty (180) days from removal; and
b. the Class B Investors shall forfeit the balance of any non-vested Class B Shares determined in accordance with the
vesting table and rules set forth in the Placement Memorandum, through the transfer of the relevant number of Class B
Shares at their initial subscription price (including all entitlements to the pro rata share in the relevant SPERA account)
less any distribution received to any such person as directed by any successor General Partner. In respect of the Class
B Shares;which shall have definitely vested in the hands of the registered holders, the holders thereof shall remain entitled
to any distribution rights attaching thereto.
It being further understood that for the purpose of determination of the entitlements under (i) or (ii) above:
a. Class B Shares shall vest ratably on a monthly basis during a given year starting on the Initial Closing Date;
b. any distributions effectively made or capable of being made to the holders of Class B Shares pursuant to the Placement
Memorandum on the basis of realized proceeds from divestments of Portfolio Companies prior to a removal (and re-
gardless of the reasons for such removal) shall be deemed to have vested as at such moment in time in the hands of their
registered holders, regardless of the vesting table set in the Placement Memorandum with no further claw-back obligation;
c. in the event that the realization and liquidation of the last investment occurs before the end of the term of the Fund,
in each case prior to the Manager and the General Partner having been revoked, then one hundred (100) per cent of the
Class B Shares shall be deemed to have vested as at such moment in time in the hands of their registered holders,
regardless of the vesting table set in the Placement Memorandum.
The Manager will procure that any Person, including without limitation an officer, partner, associate partner or any
employee of the Manager or the General Partner, eligible to beneficial interest in the Class B Shares, will be subject under
a binding contractual arrangement with the Manager and the Fund to the same vesting rules in case of removal of the
Manager or termination of service.
Neither the Manager nor the General Partner shall have any liability for any act, matter or issue arising in relation to
the Fund for the period after they are removed as general partner, manager and alternative investment fund manager of
the Fund except to the extent to which the act, matter or issue arises as a direct consequence of an act or omission of
the General Partner and/or the Manager prior to their removal.
128489
L
U X E M B O U R G
As of the resolution of Investors to remove the General Partner for or without cause, until the Investors have resolved
upon the proposed removal or, in case a judicial proceeding in connection with the proposed removal, until a final decision
without leave to appeal of a competent jurisdiction has been rendered on the proposed removal, the General Partner
and the Manager shall keep confidential, and shall not disclose, and shall make reasonable efforts to ensure that none of
its Affiliates (including any of the Manager Related Persons) discloses to any person any information in relation to the
proposed removal.
Immediately upon any decision to remove the General Partner, with or without cause the contractual arrangements
entered into by and between the General Partner and the Manager shall automatically terminate and the Manager shall
not have any entitlement against the Fund, save for the payment of the Compensation due thereunder.
Upon the removal of the General Partner, the General Meeting shall immediately appoint a replacement general partner
by way of a Special Resolution, subject to the prior CSSF approval. Such replacement general partner shall either act as
managing general partner or appoint a replacement manager and to the extent applicable or requires a replacement
alternative investment fund manager.
If the General Meeting fails to appoint a replacement general partner within six (6) weeks from the removal decision,
a General Meeting shall be convened by the dismissed General Partner within a period of four (4) weeks in order to
resolve upon the winding-up of the Fund.
Titre V. Shareholders’ meetings
Art. 23. General Meetings. The annual General Meeting shall be held each year in Luxembourg at the registered office
of the Fund on the last Wednesday of the month of April at 11.00 a.m. (Luxembourg time). If such day is not a Business
Day, the meeting will be held on the following Business Day. The first annual General Meeting will be held in 2015.
The general meeting of shareholders of the Fund may at any time be convened by the Manager.
Notices of all General Meetings, setting forth the agenda and specifying the time and place of the meeting and the
conditions of admission thereto and referring to quorum and majority requirements will be, except as otherwise provided
for by applicable Luxembourg laws and regulations, sent by registered mail to all registered shareholders, to their address
indicated in the register, at least fifteen (15) calendar days before the General Meeting.
Shareholders may waive such notice period only if one hundred (100) per cent of the shareholders consent to such
waiver.
It must be convened by the Manager upon written request of shareholders representing at least ten per cent (10%)
of the Fund's share capital. In such case, the General Meeting shall be held within a period of one (1) month from receipt
of such request.
A board of the meeting shall be formed at any General Meeting, composed of a chairman, a secretary and a scrutineer,
each of whom shall be appointed by the General Meeting and who do not need to be shareholders.
An attendance list must be kept at any General Meeting.
A shareholder may act at any General Meeting by appointing another person as his proxy in writing or by facsimile,
electronic mail or any other similar means of communication. One person may represent several or even all shareholders.
The Manager may determine other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part in any General
Meeting.
Shareholders taking part in a meeting by conference call, through video-conference or by any other means of com-
munication allowing their identification and allowing that all persons taking part in the meeting hear one another on a
continuous basis and allowing an effective participation of all such persons in the meeting, are deemed to be present for
the computation of the quorums and votes, subject to such means of communication being made available at the place
of the meeting.
Each shareholder may vote at a General Meeting through a signed voting form sent by post, electronic mail, facsimile
or any other means of communication to the Fund’s registered office or to the address specified in the convening notice.
The shareholders may only use voting forms provided by the Fund which contain at least the place, date and time of the
meeting, the agenda of the meeting, the proposal submitted to the decision of the meeting, as well as for each proposal
three boxes allowing the shareholder to vote in favour of, against, or abstain from voting on each proposed resolution
by ticking the appropriate box.
Voting forms which, for a proposed resolution, do not show only (i) a vote in favour or (ii) a vote against the proposed
resolution or (iii) an abstention are void with respect to such resolution. The Fund shall only take into account voting
forms received prior to the General Meeting which they relate to.
Art. 24. Voting. Each Share grants its holder the right to one (1) vote at any General Meeting.
Unless otherwise provided for specifically herein in the Placement Memorandum or by law, all shareholder matters
will be dealt with collectively, and not on a Share class by class level, by way of Ordinary or Special Resolutions (as defined
below) to be adopted in a General Meeting.
A special resolution shall be a resolution adopted in a General Meeting and taken by a majority of at least seventy-five
(75.00) per cent of the votes validly cast by shareholders present or represented at such meeting with a fifty (50) per
cent quorum requirement at the first meeting called or, if such quorum is not met at such first meeting, with no more
128490
L
U X E M B O U R G
quorum requirement for any succeeding meeting called to consider such the relevant resolution (each a “Special Reso-
lution”). Any changes to these Articles require a Special Resolution unless otherwise foreseen herein or the Placement
Memorandum.
An ordinary resolution shall be a resolution adopted in a General Meeting and taken by a majority of more than fifty
(50) per cent of the votes validly cast by shareholders present or represented at such meeting with no quorum require-
ment (each an “Ordinary Resolution”).
A reinforced majority resolution shall be a resolution adopted in a General Meeting and taken by a majority of two
thirds (2/3) of the votes validly cast by holders of all Class A Shares (and Class E Shares, if issued) present or represented
at such meeting with a fifty (50.00) per cent quorum requirement at the first meeting called or, if such quorum is not met
at such first meeting, without a quorum requirement for any succeeding meeting called to consider the relevant resolution
(each a “Reinforced Majority Resolution”).
The General Partner and the Manager will, and will procure that any Manager Related Person and Manager Related
Entity will:
- abstain from exercising their right to vote at any General Meeting in circumstances where any such person has a
conflict of interest;
- abstain from exercising their right to vote at any General Meeting in respect of any General Meeting resolution set
out in this Placement Memorandum where the relevant person(s) is (are) to abstain from voting at the relevant General
Meeting.
The General Partner will not have any veto right over decisions of the General Meeting.
The renunciation of the SICAR status requires the unanimous approval of all the shareholders and the prior approval
of the CSSF.
Titre VI. Accounts - Reporting - Distribution
Art. 25. Accounting Period. The accounting year of the Fund shall begin on January 1
st
of each year and it shall terminate
on December 31
st
of that same year, with the exception of the first financial year, which shall begin on the date of the
Fund’s incorporation and shall terminate on 31
st
December 2014.
Art. 26. Reporting. All accounting and reporting-related tasks will be the responsibility of the Manager who has dele-
gated certain functions thereof to the Administrative Agent. All accounting tasks will be performed by the Accounting
and Calculation Agent appointed by the Manager. Additionally, the Manager employs in-house accounting professionals
charged with obtaining and reviewing all investment reporting and the Fund’s accounting, as well as with compiling the
quarterly and annual reports, when appropriate, for reporting to Investors, the General Partner and the Supervisory
Authority.
The Manager will communicate to Investors, within sixty (60) calendar days of the end of each quarter, reports in
relation to (i) acquisitions and disposals made by the Fund since the last quarterly report, (ii) the Fund’s unaudited financial
statements established in conformity with Lux GAAP, (iii) anticipated acquisitions and disposals and (iv) details of other
material developments related to the business of the Portfolio Companies. Additionally, the Manager will at the occasion
of the annual General Meeting report on the business activities and financial affairs of the Fund.
The Manager will issue an audited annual report in respect of the Fund, which will be made available to Investors within
ninety (90) calendar days after quarter end, and in any case before the annual General Meeting, to be held at the registered
office of the Fund in Luxembourg on the last Wednesday of the month of April at 11.00 a.m. (Luxembourg time) and for
the first time in 2015. The first annual report will be prepared in respect of the financial year ending on 31 December
2014.
The Manager will at all times ensure the flow of information necessary for the fulfilment of the tasks of the various
parties involved between such parties.
The Manager will follow the IPEV Reporting Guidelines, as described in more detail in the Placement Memorandum.
Art. 27. Audit. The operations of the Fund and its financial situation shall be reviewed by an independent auditor
qualifying as a réviseur d’entreprises agréé who shall be appointed by the Manager. The independent auditor shall be
remunerated by the Fund and shall remain in office until its successor is appointed. The independent auditor shall fulfil all
duties prescribed by the 2004 Law.
Art. 28. Depositary. Under a depositary bank and services agreement for a SICAR (the “Services Agreement”) entered
into by and between the Manager, acting for and on behalf of the Fund and Edmond de Rothschild (Europe), Edmond de
Rothschild (Europe) (in such capacity, the “Depositary”) has undertaken to provide depositary bank, custody services as
well as paying agent services in respect of the Fund’s assets.
The Depositary is responsible for the general supervision of the assets of the Fund, the cash monitoring and the custody
of the assets entrusted to it in accordance with the AIFM Law. For the custody of the assets entrusted to it, the Depositary
may appoint correspondents, which shall, in such instance, be selected under its responsibility with professional care and
in good faith, amongst professional service providers duly authorized to carry out their functions in the relevant juris-
dictions.
128491
L
U X E M B O U R G
In consideration for its services, the Depositary shall be paid a fee out of the assets of the Fund, as determined from
time to time in accordance with the Services Agreement in accordance with market practice in Luxembourg.
The Services Agreement may be terminated by either the Manager, acting for and on behalf of the Fund or the De-
positary upon ninety (90) calendar days’ prior written notice. The Depositary will have to be replaced within two (2)
months from its voluntary withdrawal or its removal by the Manager. The Depositary shall continue its activities until the
Fund's assets have been transferred to the new depositary bank.
Art. 29. Distributions. Net Proceeds attributable to the disposition of investments in Portfolio Companies, together
with any dividend or interest income received with respect to investments in Portfolio Companies, will be distributed as
follows:
a) first, to holders of Class A Shares (and, where applicable, Class E Shares each time within the limits of the economic
entitlements pertaining to the relevant Excluded Investment) pro rata among them, one hundred (100.00) per cent of
Net Proceeds until such time when each Investor will have received
i. an amount equal to that Investor’s Commitments plus
ii. an amount such that Investor will have received distributions under item i. and this item ii. equal to 1.1 times that
Investor’s Commitment;
b) second, any Net Proceeds available thereafter to holders of Class B Shares until an amount corresponding to twenty
five (25.00) per cent of the amounts paid under a) ii above has been returned; and
c) thereafter, of any remaining Net Proceeds eighty (80.00) per cent to the holders of Class A Shares pro rata (and,
where applicable, Class E Shares each time within the limits of the economic entitlements pertaining to the relevant
Excluded Investment) and twenty (20.00) per cent to the holders of Class B Shares.
If upon the earlier of (i) the time of the dissolution of the Fund and (ii) such time when the Manager notifies the holders
of Class A Shares and Class E Shares that it will draw down no further portion of any undrawn Commitment (provided
however that a release from undrawn Commitments by the Manager cannot be in excess of ten (10.00) per cent of the
respective Commitments of the Investors) the total distributions made to those classes exceeding respect of each Investor
1.1 times that Investor’s (adjusted) Commitment, the Manager shall be entitled to request reimbursement of the excess
funds to the Fund (or set off such excess amount against any potential distributions/payments due to such Investors by
the Fund) in an amount equal to the greater of: (i) the amount, if any, by which distribution to any Investors exceeds 1.1
times that Investor’s (adjusted) Commitment, and (ii) the amount, if any, by which the cumulative distributions to holders
of Class B Shares fell short of the amounts distributable to the holders of Class B Shares pursuant to the distribution
mechanism stated above, applied on an aggregate basis covering all transactions/investments of the Fund after adjustment
to each Investor’s Commitment.
The Manager will distribute all Net Proceeds (via redemption of a corresponding number of Shares) (or out of the
SPERA, each time on a pro rata basis) (as applicable within the limits of an Excluded Investment in order to maintain
segregation of assets and liabilities established within the relevant Class E Shares or Sub-Class and the corresponding
SPERA) as soon as practicable after receipt thereof subject to its capacity to retain all or part of such funds for reinvestment
and provided further, however, that the Manager may cause the Fund to retain any proceeds otherwise distributable (and
to keep reserves within the Fund if i) such amounts do not exceed two (2.00) per cent of Aggregate Commitments, in
which case they may be distributed as an annual dividend, and (ii) to enable the Fund to pay expenses, and otherwise
satisfy the Fund’s obligations, which such expenses and obligations must be foreseeable and payable in the short term (i.e.
within a maximum of three months) as from receipt of the relevant amount and provided in that case that any amount
retained for that purpose will be (i) notified to the Investor Advisory Committee and (ii) immediately distributed to
Investor if unused at the end of the three months period.
The Fund shall have the right, if the Manager so determines, to proceed to distributions in specie of any securities
listed on internationally recognized and regulated stock exchange to any Investor who agrees thereto, by allocating to
such Investor investments from the portfolio of assets of the Fund equal to the value of distributions to which it is entitled.
The assets to be transferred in such case shall be determined on a fair and reasonable basis and without prejudicing the
interests of the other Investors and the valuation used shall be based on the average stock price quoted on the relevant
stock exchange over the last ten (10) to fifteen (15) Business Days before distribution. The costs of any such in specie
distribution shall be borne by the transferee.
Any taxes withheld by the Fund from distributions to an Investor or any taxes withheld from proceeds to the Fund
or otherwise paid by the Fund that is allocable to an Investor plus any interest, additions to tax and penalties with respect
thereto (“Tax Advance”) shall be deemed to have been distributed to such an Investor. To the extent that such Tax
Advance exceeds the cash distribution that such Investor would have received but for the Tax Advance, the Manager
shall notify such Investor as to the amount of such excess and such Investor shall make a prompt payment to the Fund
of such amount plus interest thereon at a rate equal to Euribor plus two (2.00) per cent as of the date of the Tax Advance,
which payment shall not constitute a capital contribution.
In any event and except in the case of an orderly liquidation payment, no distribution or redemption of Shares may
be made if, as a result, the Net Asset Value of the Fund would fall below one million euros (€ 1,000,000).
128492
L
U X E M B O U R G
Any distribution and/or any redemption proceeds that have not been claimed within five (5) years of their declaration
shall be forfeited and paid to the “Caisse des Dépôts et Consignations”.
Titre VII. Liquidation
Art. 30. Liquidation. In the event of voluntary dissolution of the Fund, the liquidation may be carried out by the Manager,
acting as liquidator of the Fund, pursuant to the SICAR Law and the Placement Documents, and subject to the prior
approval of the CSSF.
Amounts which have not been claimed by Investors at the close of the liquidation will be deposited in escrow with
the Caisse de Consignations in Luxembourg. Should such amounts not be claimed within the prescription period, they
will be forfeited.
Any appointed liquidator(s) shall be subject to the full compliance with all the provisions of the Placement Memoran-
dum.
Titre VIII. General provisions
Art. 31. Amendments to these Articles. These Articles may be amended by a General Meeting in accordance with the
provisions set out in the Placement Memorandum, article 24 above and the 1915 Law, each time subject to the prior
approval of the CSSF.
Art. 32. Applicable Law. Reference is made to the provisions of the 1915 Law, the AIFM Law and the 2004 Law for
which no specific provision is made in these Articles.
<i>Transitional provisionsi>
The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Fund and terminate on 31 December 2014.
The first annual general meeting of shareholders shall be held in 2015.
Interim dividends may also be distributed during the Fund’s first financial year.
<i>Subscription and paymenti>
The two thousand one (2001) issued shares have been subscribed as follows:
- One thousand (1000) Class B Shares have been subscribed by Mangrove IV Partners SCSp, aforementioned, for the
price of one euro cent (EUR 0.01) each;
- One thousand (1000) Class B Shares have been subscribed by Mangrove Equity Partners SCSp, aforementioned, for
the price of one euro cent (EUR 0.01) each; and
- One (1) Management Share has been subscribed by Mangrove IV GP S.à r.l., aforementioned, for the price of forty-
nine thousand nine hundred eighty euros (EUR 49,980).
The shares so subscribed have been fully paid-up by a contribution in cash so that the amount of two hundred forty-
nine thousand nine hundred eighty euros (EUR 249,980) is as of now available to the Fund, as it has been justified to the
undersigned notary.
Out of the total contribution in the amount of two hundred forty-nine thousand nine hundred eighty euros (EUR
249,980) consists of fifty thousand euros (EUR 50,000) have been allocated to the share capital and one hundred ninety-
nine thousand nine hundred eighty euros (EUR 199,980) have been allocated to the special equity reserve account.
<i>Declarationi>
The undersigned notary herewith declares that he has verified the existence of the conditions provided for or referred
to in articles 26 of the Law and expressly states that they have been complied with.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Fund or which shall be borne
by the Fund in connection with its incorporation are estimated at approximately one thousand six hundred Euro (EUR
1600.-)
<i>Resolutions of the shareholdersi>
The incorporating shareholders, representing the entire share capital of the Fund and having waived any convening
requirements, have passed the following resolutions:
1. The address of the registered office of the Fund is set at 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg,
2. The general meeting of shareholders resolves to create an authorised capital in the Company with waiver of the
preferential subscription rights of the existing shareholders in respect thereto, in a total amount of amount of twenty-
five thousand euros (€ 25,000) (excluding the issued share capital), consisting of two million five hundred thousand
(2,500,000) Class A Shares, having a nominal value of one euro cent (€ 0.01).
128493
L
U X E M B O U R G
3. The following person is appointed as Manager and Alternative Investment Fund Manager of the Fund with immediate
effect:
Mangrove Capital Partners S.A., a public limited liability company (société anonyme) incorporated and existing under
the laws of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ under number B 74666, having its
registered office at 31, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
4. The independent auditor for the Company shall be Deloitte Audit, with registered office at 560, rue de Neudorf,
L-2220 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. The auditor shall remain in office until the close of annual general
meeting approving the accounts of the Company as of 31 December 2014.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-
ment.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,
this deed is worded in English.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name
and residence, the said proxyholder of the appearing parties signed together with the notary the present deed.
Signé: M. CAMARA, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 24 juillet 2014. Relation: DIE/2014/9432. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.
<i>Le Receveuri>
(signé) pd: RECKEN.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Diekirch, le 28 juillet 2014.
Référence de publication: 2014114242/741.
(140134231) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2014.
GEVAPAN INVEST Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 22.653.
L'an deux mille quatorze, le douze juin.
Par-devant Maître Marc LECUIT, notaire de résidence à Mersch.
S’EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «GEVAPAN INVEST Spf S.A.», ayant son
siège social à L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés,
numéro B 22653, constituée suivant acte reçu par Maître Reginald NEUMAN, notaire alors de résidence à Luxembourg,
en date du 14 mars 1985, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 104 du 13 avril 1985 (ci-
après la «Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte
reçu par Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 11 septembre 2007, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 746, du 27 mars 2008, suivi d’un acte rectificatif reçu par Maître
Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16 avril 2009, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 1045, du 20 mai 2009.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Vanessa ALEXANDRE, juriste, demeurant professionnellement
à L-7593 Beringen, 7, rue Wenzel. (ci-après le «Président»).
L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Sandrine ORTWERTH, salariée, demeurant professionnellement à
L-1724 Luxembourg, 3A, Boulevard Prince Henri
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour le suivant (ci-après l’«Ordre du jour»):
- Renonciation aux modalités légales relatives aux convocations de l’assemblée;
- Dissolution anticipée et mise en liquidation de la Société;
- Nomination du liquidateur et définition de ses pouvoirs;
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence.
Cette liste de présence, après avoir été paraphée «ne varietur» par les actionnaires présents, les mandataires des
actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
«ne varietur» par les comparants et le notaire instrumentaire.
128494
L
U X E M B O U R G
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’Ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut dès lors
délibérer valablement sur les points portés à l’Ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'admi-
nistration à proposer les points figurant à l’Ordre du Jour.
L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à la présente assemblée, celle-ci décide de renoncer aux
formalités de convocation, les actionnaires de la Société représentés à l’assemblée se considérant comme dûment con-
voqués et déclarant avoir pris connaissance de l’Ordre du jour qui leur a été communiqué par avance.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide la dissolution anticipée de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce
jour.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide de nommer comme liquidateur de la Société, Monsieur Etienne GILLET, expert-comptable, né à
Bastogne (Belgique) le 19 septembre 1968, demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 3A, Boulevard du
Prince Henri (ci-après le «Liquidateur»).
Le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés
commerciales.
Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée générale dans les
cas où elle est requise.
Le Liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires
telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.
<i>Fraisi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société ou qui sont
mis à sa charge à raison du présent acte s’élève approximativement à HUIT CENTS EUROS (800.- EUR).
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, toutes connues du notaire par nom, prénom, qualité
et demeure, ces dernières ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: S. ORTWERTH, V. ALEXANDRE, M. LECUIT.
Enregistré à Mersch, le 13 juin 2014. Relation: MER/2014/1199. Reçu soixante-quinze euros 75,00€.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): E. WEBER.
POUR COPIE CONFORME.
Mersch, le 24 juillet 2014.
Référence de publication: 2014110478/73.
(140131941) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2014.
C7 Massylux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 112.874.
Suivant décision du gérant, en date du 17 Juillet 2014, le siège social de la société a été transféré du 2-4 avenue Marie-
Thérèse L-2132 Luxembourg au 121 avenue de la Faïencerie L-1511 Luxembourg, à compter du 1
er
août 2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2014121242/12.
(140139430) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2014.
128495
L
U X E M B O U R G
Pro Energies S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4123 Esch-sur-Alzette, 4, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 162.921.
L'an deux mille quatorze, le trente juillet.
Pardevant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "PRO ENERGIES S.A.", établie et ayant
son siège social à L-1750 Luxembourg, 4-6, Avenue Victor Hugo, constituée suivant acte reçu par Maître Roger AR-
RENSDORFF, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, en date du 2 août 2011, publié au Mémorial C numéro 2412 du
7 octobre 2011, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro numéro B 162921.
La séance est ouverte à 15.00 heures sous la présidence de Monsieur Noyri LAROUSSI, directeur technique, demeu-
rant à L-2430 Luxembourg, 19, rue Michel Rodange.
Le Président désigne comme secrétaire et scrutateur Monsieur Alain LEMAIRE, chef de chantier, demeurant à L-2430
Luxembourg, 19, rue Michel Rodange.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1.- Transfert du siège social de la société de L-1750 Luxembourg, 4-6, Avenue Victor Hugo, à L-4123 Esch-sur-Alzette,
4, rue du Fossé et modification subséquente du premier alinéa de l'article 3 des statuts.
2.- Divers.
II.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les MILLE (1.000)
actions d'une valeur nominale de TRENTE-ET-UN EUROS (31.-EUR) chacune, représentant l'intégralité du capital social
souscrit d'un montant de TRENTE-ET-UN MILLE EUROS (31.000.-EUR), sont dûment représentées à la présente as-
semblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut ainsi délibérer et décider valablement sur les points
figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti
à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.
Restera pareillement annexée aux présentes la liste de présence, laquelle, après avoir été signée "ne varietur" par les
membres du bureau et le notaire instrumentant, sera soumise avec ledit acte aux formalités de l'enregistrement.
L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et, après s'être reconnue régulièrement consti-
tuée, a abordé l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix, la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de L-1750 Luxembourg, 4-6, Avenue Victor
Hugo, à L-4123 Esch-sur-Alzette, 4, rue du Fossé et de modifier en conséquence le premier alinéa de l'article 3 des statuts
qui aura la teneur suivante:
"Le siège social de la société est établi à Esch-sur-Alzette".
Le 2
ème
alinéa de l'article 3 des statuts reste inchangé.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance.
<i>Fraisi>
Tous les frais et honoraires, quels qu'ils soient, dus en vertu des présentes sont à la charge de la société.
DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par noms,
prénoms, états et demeures, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.
Signé: LAROUSSI, LEMAIRE, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 31/07/2014. Relation: EAC/2014/10577. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): HALSDORF.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.
Esch-sur-Alzette, le 04 août 2014.
Référence de publication: 2014123078/50.
(140140298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2014.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
128496
21st Century Soccer S.à r.l.
Argon Investment S.à r.l.
Avolon Holding Corporation (Luxembourg) III S.à r.l.
C5 Partners S.C.A.
C7 Massylux S.à r.l.
Chelsea Wharf Holdings S.à r.l.
Chronotron S.à r.l.
Eggon S.A.
EuroInformation International
Even RX Zehn S.à r.l.
Even RX Zwölf S.à r.l.
Ever Capital S.à r.l.
Ever Capital S.à r.l.
Ever Capital S.à r.l.
Falconer II S.à r.l.
Falconer II S.à r.l.
FGL Lux Holdings, S.à r.l.
Fiduciaire Claude Uhres et Cie S.A.
Fiduciaire Luxembourg Paris Genève S.à r.l.
Fiduciaire Principale
Fiducis
Filvest Management S.à r.l.
Fimaco International S.A.
Fior Ateliers S.à r.l.
Fitlosophy S.à r.l.
FM Investment
Fondation AGGL - FNEL
Freepost S.à r.l.
FRM Participations S.A.
FundTap S.à r.l.
Galapagos LuxCo S.à r.l.
Galeria K S.à r.l.
GEVAPAN INVEST Spf S.A.
Global Indemnity (Luxembourg) S.à r.l.
GMT Bigstar S.à r.l.
Greening Partners International S.àr.l.
GWA SIF
Harmonie Cuisines S.A.
Hasenkamp Luxemburg S.à r.l.
Heco S.A., SPF
Heinz Finance (Luxembourg) S.à r.l.
Helis
H.I.G. Luxembourg Holdings 48 S.à r.l.
HSBC Equities (Luxembourg) S.à r.l.
IMAGE3G S.à r.l.
Mangrove IV (SCA), SICAR
Pro Energies S.A.
Randstad Group Luxembourg S.à r.l.
Real Estate Property 7 S.A.
Robelco International Real Estate Developments S.A.
Robien S.A.
Saddle Luxco Holding S.à r.l.
Scala International S.A.
SDA International S.à r.l.
Sernami Invest S.A.
Silver Star Investment S.à r.l.
Société d'investissement Afrique Méditerranée
Staco International SA
Sunny Seasons S.A.
Villa Lago Holding S.A.
Way LuxCo S.à r.l.