This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2669
2 octobre 2014
SOMMAIRE
Alcentra Mezzanine QPAM S.à r.l. . . . . . . .
128112
Dimple Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128102
Dominium Holdco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
128075
Energreen Investment S.à r.l. . . . . . . . . . . .
128089
Eurasian Resources Group . . . . . . . . . . . . . .
128086
Euroland Properties S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
128100
Fa Capital S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128091
Fondation Autisme-Luxembourg . . . . . . . .
128106
JER Manhattan S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128066
JER Trafalgar S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128066
KAILUA S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128067
K.B.S. Construction S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
128066
Kennametal Luxembourg Holding S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128066
Kikuoka Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . .
128068
Kinetek Luxco GP S.à r.l. & Partners S.C.S.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128068
Kiwi Media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128067
KoBauLux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128067
Koudourrou S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128068
KR Real Estate Corporation S.à r.l. . . . . . .
128071
Kwasa Europe S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128069
La Languette S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128070
L.B.T.V. s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128070
Le Comptoir du Pain S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
128070
Leopard Germany Property 1 S.à r.l. . . . .
128072
Leopard Germany Property 2 S.à r.l. . . . .
128070
Leopard Germany Property 3 S.à r.l. . . . .
128074
Leopard Germany Property Ed 2 S.à.r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128067
Leopard Germany Property Ed 3 S.à.r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128073
Leopard Germany Property Ed 4 S.à.r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128070
Leopard Germany Property ME 2 S.àr.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128071
Links Bidco S.à r.l. Propco 1 . . . . . . . . . . . . .
128069
Links Bidco S.à r.l. Propco 10 . . . . . . . . . . .
128069
Links Bidco S.à r.l. Propco 11 . . . . . . . . . . .
128071
Links Bidco S.à r.l. Propco 12 . . . . . . . . . . .
128071
Links Bidco S.à r.l. Propco 2 . . . . . . . . . . . . .
128072
Links Bidco S.à r.l. Propco 3 . . . . . . . . . . . . .
128072
Links Bidco S.à r.l. Propco 4 . . . . . . . . . . . . .
128072
Links Bidco S.à r.l. Propco 5 . . . . . . . . . . . . .
128073
Links Bidco S.à r.l. Propco 6 . . . . . . . . . . . . .
128073
Links Bidco S.à r.l. Propco 7 . . . . . . . . . . . . .
128073
Links Bidco S.à r.l. Propco 8 . . . . . . . . . . . . .
128074
Links Bidco S.à r.l. Propco 9 . . . . . . . . . . . . .
128074
Lombard Odier Investment Managers Pri-
vate Equity Investments . . . . . . . . . . . . . . .
128071
Lone Star Capital Investments S.à r.l. . . . .
128072
Luxembourg Airport Centre . . . . . . . . . . . .
128073
Luxembourg Boulevard Royal Centre . . . .
128074
Lux Flex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128074
Moda Inc. s.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128066
Montagna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128112
New Quasar S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128111
Ozero Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128090
PremTech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128067
Private Market Opportunities Fund SICAV
SIF S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128068
Sea-Invest Afrique S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
128110
Senior European Loan Fund SCA-SIF . . . .
128108
WP Merger S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128068
WP Roaming III S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
128069
WP Roaming I S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128069
X-Rite Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
128083
128065
L
U X E M B O U R G
JER Manhattan S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 116.035.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2014110616/10.
(140131798) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2014.
JER Trafalgar S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 115.444.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2014110617/10.
(140131802) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2014.
Kennametal Luxembourg Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 22.429.683,00.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 154.168.
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juillet 2014.
Référence de publication: 2014110629/10.
(140132714) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2014.
K.B.S. Construction S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8715 Everlange, 6, rue du Pont.
R.C.S. Luxembourg B 101.690.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014110624/9.
(140131809) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2014.
Moda Inc. s.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9905 Troisvierges, 81, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 102.488.
<i>Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue au siège social le 21 juillet 2014i>
<i>Décisioni>
Il est porté à la connaissance des tiers, qu'à partir du 21 juillet 2014, le siège social de la société MODA INC. s.à.r.l.
va être transférer vers l'adresse suivante:
81, Grand-Rue
L- 9905 Troisvierges
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014110794/15.
(140132158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2014.
128066
L
U X E M B O U R G
Kiwi Media, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8399 Windhof, 13, rue de l'Industrie.
R.C.S. Luxembourg B 180.539.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014110644/10.
(140131817) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2014.
KoBauLux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4531 Differdange, 166, avenue Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 167.677.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014110635/9.
(140131871) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2014.
KAILUA S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 4, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 42.892.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
KAILUA S.A.
Référence de publication: 2014110637/10.
(140132115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2014.
Leopard Germany Property Ed 2 S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 20.000,00.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 55, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 155.843.
Les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 juillet 2014.
M. Robert Kimmels
<i>Géranti>
Référence de publication: 2014110657/13.
(140132649) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2014.
PremTech, Société Anonyme.
Siège social: L-5860 Hesperange, 31, rue Camille Mersch.
R.C.S. Luxembourg B 181.550.
EXTRAIT
Monsieur Thomas KEIPES est révoqué de son mandat d'administrateur délégué de la Société avec effet au 21 juillet
2014.
Pour extrait
<i>Pour la Sociétéi>
Référence de publication: 2014110860/12.
(140132127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2014.
128067
L
U X E M B O U R G
Private Market Opportunities Fund SICAV SIF S.A., Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds
d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 168.936.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Private Market Opportunities Fund SICAV SIF S.A.
i>Caceis Bank Luxembourg
Référence de publication: 2014110861/12.
(140131683) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2014.
Kikuoka Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5412 Canach, Scheierhaff.
R.C.S. Luxembourg B 28.646.
Les documents de clôture de l'année 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 24 juillet 2014.
Référence de publication: 2014110642/10.
(140131749) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2014.
Kinetek Luxco GP S.à r.l. & Partners S.C.S., Société en Commandite simple.
Capital social: EUR 150.000,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 121.738.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 juillet 2014.
Référence de publication: 2014110631/10.
(140132453) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2014.
Koudourrou S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle Rolach.
R.C.S. Luxembourg B 55.348.
Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2014110646/10.
(140132295) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2014.
WP Merger S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 278.000,00.
Siège social: L-5326 Contern, 15, rue Edmond Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 124.534.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour WP Merger S.àr.l.
i>Mr. Nelson Murphy
<i>Manageri>
Référence de publication: 2014111091/12.
(140132166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2014.
128068
L
U X E M B O U R G
Links Bidco S.à r.l. Propco 1, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 175.441.
Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
Référence de publication: 2014110668/10.
(140132684) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2014.
WP Roaming III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 38.759.250,00.
Siège social: L-5326 Contern, 15, rue Edmond Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 109.535.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour WP Roaming III S.àr.l.
i>Mr. Nelson Murphy
<i>Manageri>
Référence de publication: 2014111093/12.
(140132165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2014.
Links Bidco S.à r.l. Propco 10, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 175.459.
Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
Référence de publication: 2014110669/10.
(140132677) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2014.
Kwasa Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 179.183.
Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
Référence de publication: 2014110648/10.
(140131752) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2014.
WP Roaming I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 3.513.800,00.
Siège social: L-5326 Contern, 15, rue Edmond Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 108.604.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour WP Roaming I S.àr.l.
i>Mr. Nelson Murphy
<i>Manageri>
Référence de publication: 2014111092/12.
(140132164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2014.
128069
L
U X E M B O U R G
L.B.T.V. s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4479 Soleuvre, 3, rue des Prés.
R.C.S. Luxembourg B 128.009.
Le bilan et l'annexe au bilan au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014110650/10.
(140132258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2014.
La Languette S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7333 Steinsel, 71, rue des Prés.
R.C.S. Luxembourg B 129.295.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014110651/9.
(140132315) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2014.
Leopard Germany Property 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 55, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 152.689.
Les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 juillet 2014.
M. Robert Kimmels
<i>Géranti>
Référence de publication: 2014110663/13.
(140132645) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2014.
Leopard Germany Property Ed 4 S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 20.000,00.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 55, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 155.845.
Les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 juillet 2014.
M. Robert Kimmels
<i>Géranti>
Référence de publication: 2014110659/13.
(140132647) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2014.
Le Comptoir du Pain S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 19, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 56.618.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014110706/9.
(140132192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2014.
128070
L
U X E M B O U R G
Leopard Germany Property ME 2 S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 20.000,00.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 55, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 156.040.
Les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 juillet 2014.
M. Robert Kimmels
<i>Géranti>
Référence de publication: 2014110661/13.
(140132642) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2014.
KR Real Estate Corporation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 108.219.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juillet 2014.
Référence de publication: 2014110647/10.
(140132435) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2014.
Links Bidco S.à r.l. Propco 11, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 175.460.
Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
Référence de publication: 2014110670/10.
(140132675) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2014.
Links Bidco S.à r.l. Propco 12, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 175.461.
Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
Référence de publication: 2014110671/10.
(140132674) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2014.
LOIM PE Investments, Lombard Odier Investment Managers Private Equity Investments, Société en
Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 155.458.
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juillet 2014.
Référence de publication: 2014110683/11.
(140132638) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2014.
128071
L
U X E M B O U R G
Leopard Germany Property 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 20.000,00.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 55, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 152.687.
Les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 juillet 2014.
M. Robert Kimmels
<i>Géranti>
Référence de publication: 2014110662/13.
(140132644) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2014.
Links Bidco S.à r.l. Propco 3, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 175.452.
Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
Référence de publication: 2014110673/10.
(140132676) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2014.
Links Bidco S.à r.l. Propco 2, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 175.451.
Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
Référence de publication: 2014110672/10.
(140132685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2014.
Links Bidco S.à r.l. Propco 4, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 175.455.
Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
Référence de publication: 2014110674/10.
(140132683) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2014.
Lone Star Capital Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.
R.C.S. Luxembourg B 91.796.
Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juillet 2013.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2014110684/11.
(140132156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2014.
128072
L
U X E M B O U R G
Leopard Germany Property Ed 3 S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 20.000,00.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 55, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 155.844.
Les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 juillet 2014.
M. Robert Kimmels
<i>Géranti>
Référence de publication: 2014110658/13.
(140132648) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2014.
Links Bidco S.à r.l. Propco 5, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 175.502.
Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
Référence de publication: 2014110675/10.
(140132682) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2014.
Links Bidco S.à r.l. Propco 6, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 175.453.
Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
Référence de publication: 2014110676/10.
(140132681) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2014.
Links Bidco S.à r.l. Propco 7, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 175.478.
Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
Référence de publication: 2014110677/10.
(140132680) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2014.
Luxembourg Airport Centre, Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 179.645.
Il est porté à la connaissance de tous que les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
Référence de publication: 2014110688/11.
(140132806) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2014.
128073
L
U X E M B O U R G
Leopard Germany Property 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 20.000,00.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 55, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 152.690.
Les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 juillet 2014.
M. Robert Kimmels
<i>Géranti>
Référence de publication: 2014110664/13.
(140132646) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2014.
Links Bidco S.à r.l. Propco 8, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 175.454.
Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
Référence de publication: 2014110678/10.
(140132679) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2014.
Links Bidco S.à r.l. Propco 9, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 175.497.
Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
Référence de publication: 2014110679/10.
(140132678) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2014.
Lux Flex, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 155.038.
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juillet 2014.
Référence de publication: 2014110686/10.
(140132712) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2014.
Luxembourg Boulevard Royal Centre, Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 42.802.
Il est porté à la connaissance de tous que les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
Référence de publication: 2014110689/11.
(140132804) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2014.
128074
L
U X E M B O U R G
Dominium Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 188.989.
STATUTES
In the year two thousand and fourteen, on the twenty-first day of the month of July.
Before Maître Cosita Delvaux, notary, residing in Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Dominium Pledgeco S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited liability company) incorporated under
the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
having a share capital of twelve thousand and five hundred Euros (EUR 12,500) and in the process of being registered
with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg,
represented by Ms Sandra Mohand-Oussaïd, lawyer, professionally residing in Luxembourg pursuant to a proxy dated
on 17 July 2014 which shall be registered together with the present deed.
The appearing party, acting in the above stated capacity, has requested the undersigned notary to draw up the articles
of incorporation of a limited liability company Dominium Holdco S.à r.l. (société à responsabilité limitée) which is hereby
established as follows:
Art. 1. Denomination. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name “Dominium Holdco
S.à r.l.” (the “Company”) is hereby formed by the appearing party and all persons who will become shareholders the-
reafter. The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.
Art. 2. Object. The object of the Company shall be the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg
and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and
development of its portfolio.
The Company may also carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of real estate,
properties and real estate rights in Luxembourg and abroad as well as any participations in any real estate enterprise or
undertaking in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those participa-
tions and assets.
The Company may further give guarantees, grant security interests, grant loans or otherwise assist the companies in
which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may also acquire loans including at a discount, originate loans and lend funds under any form, advance
money or give credit on any terms including without limitation resulting from any borrowings of the Company or from
the issue of any equity or debt securities of any kind to any person or entity as it deems fit in relation to any real estate
enterprise or undertaking. The Company may enter into swaps, futures, forwards, derivatives, options, repurchase, stock
lending and similar transactions, and, without prejudice to the generality of the foregoing, employ any techniques and
instruments in connection with its real estate activities. The Company may also enter into any guarantees, contracts of
indemnities, security interests and any other equivalent agreements in order to receive the benefit of any guarantee and/
or security interest granted in the context of such real estate activities. The Company may undertake any roles necessary
in connection with such lending activity including, without limitation, the role of arranger, lead manager, facility agent,
security agent, documentation agent. The Company shall not undertake such real estate lending or real estate loan
acquisition activities in a way that would require it to be regulated pursuant to the Luxembourg act dated 5 April 1993
on the financial sector, as amended or any future act or regulation amending or replacing such act.
The Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or indirectly
in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purposes.
In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their admi-
nistration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other
advisors.
Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period.
Art. 4. Registered Office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an
extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles of
association.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the
case may be the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
128075
L
U X E M B O U R G
In the event that the manager, or as the case may be the board of managers, should determine that extraordinary
political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances;
such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified
to any interested parties by the manager or as the case may be the board of managers.
Art. 5. Share capital. The issued share capital of the Company is set at twelve thousand and five hundred Euros (EUR
12,500) represented by five hundred (500) shares with a nominal value of twenty-five Euros (EUR 25) each. The capital
of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for
amendment of these articles of association and the Company may proceed to the repurchase of its other shares upon
resolution of its shareholders.
Any available share premium shall be distributable.
Art. 6. Transfer of Shares. Shares are freely transferable among shareholders. Except if otherwise provided by law, the
share transfer to non-shareholders is subject to the consent of shareholders representing at least seventy-five per cent
(75%) of the Company's share capital.
Art. 7. Management of the Company. The Company is managed by one or several managers who do not need to be
shareholders.
In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers.
The sole manager or as the case may be, the board of managers, is vested with the broadest powers to manage the
business of the Company and to authorise and/or perform all acts of disposal and administration falling within the purposes
of the Company. All powers not expressly reserved by the law or by the articles of association to the general meeting
shall be within the competence of the sole manager or as the case may be, the board of managers.
Vis-à-vis third parties the sole manager or as the case may be, the board of managers, has the most extensive powers
to act on behalf of the Company in all circumstances and to do, authorise and approve all acts and operations relative to
the Company and not reserved by law or these articles of association to the general meeting of shareholders.
The managers are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of share-
holders, which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed
for an undetermined period. The managers may be re-elected but their appointment may also be revoked with or without
cause (ad nutum) at any time.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means
of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one
another. A meeting may also at any time be held by conference call or similar means only. The participation in, or the
holding of, a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting
in person. Managers may be represented at meetings of the board by another manager without limitation as to the number
of proxies which a manager may accept and vote.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours (24) at
least in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by cable, telegram, telex, e-mail or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening
notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted
by the board of managers.
Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company.
The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman of that meeting or, in its absence,
by any two managers. Copies or excerpts of such minutes shall be signed by the chairman of that meeting or by any two
managers.
The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means
when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety
will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including circular
resolutions, may be conclusively certified or an extract thereof may be issued under the individual signature of any
manager.
The Company will be bound by the sole signature in the case of a sole manager, and in the case of a board of managers
by the sole signature of anyone of the managers. In any event the Company will be validly bound by the sole signature of
any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by the sole manager (if there is only
one) or as the case may be the board of managers or anyone of the managers.
Art. 8. Liability of the Managers. The manager(s) are not held personally liable for the indebtedness of the Company.
As agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties.
128076
L
U X E M B O U R G
Subject to the exceptions and limitations listed below, every person who is, or has been, a manager or officer of the
Company shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against all
expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding which he becomes
involved as a party or otherwise by virtue of his being or having been such manager or officer and against amounts paid
or incurred by him in the settlement thereof. The words "claim", "action", "suit" or "proceeding" shall apply to all claims,
actions, suits or proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words "liability"
and "expenses" shall include without limitation attorneys' fees, costs, judgements, amounts paid in settlement and other
liabilities.
No indemnification shall be provided to any manager or officer:
(i) against any liability to the Company or its shareholders by reason of wilful misfeasance, bad faith, gross negligence
or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office;
(ii) with respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated to have acted in bad faith and not in
the interest of the Company; or
(iii) in the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of competent jurisdiction or by
the board of managers.
The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any manager
or officer may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such manager or officer
and shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein shall
affect any rights to indemnification to which corporate personnel, including directors and officers, may be entitled by
contract or otherwise under law.
Expenses in connection with the preparation and representation of a defence of any claim, action, suit or proceeding
of the character described in this article shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof upon receipt
of any undertaking by or on behalf of the officer or director, to repay such amount if it is ultimately determined that he
is not entitled to indemnification under this article.
Art. 9. Shareholder voting rights. Each shareholder may take part in collective decisions. He has a number of votes
equal to the number of shares he owns and may validly act at any meeting of shareholders through a special proxy.
Art. 10. Shareholder meetings. Decisions by shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as pre-
scribed by Luxembourg Company law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings. Any regularly constituted
meeting of shareholders of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the entire
body of shareholders of the Company.
Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to shareholders to their address appearing
in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting.
If the entire share capital of the Company is represented at a meeting, the meeting may be held without prior notice.
In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the shareholders at their addresses
inscribed in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days before the proposed effective date
of the resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for
collective decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous
written resolution may be passed at any time without prior notice.
Except as otherwise provided for by law, (i) decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by
shareholders representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting or
first written resolution, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions
shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented. (ii) However, decisions
concerning the amendment of the articles of association are taken by (x) a majority of the shareholders (y) representing
at least three quarters of the issued share capital and (iii) decisions to change of nationality of the Company are to be
taken by Shareholders representing one hundred percent (100%) of the issued share capital.
At no time shall the Company have more than thirty (30) shareholders. At no time shall an individual be allowed to
become a shareholder of the Company.
Art. 11. Accounting Year. The accounting year begins on 1
st
January of each year and ends on 31
st
December of the
same year save for the first accounting year which shall commence on the day of incorporation and end on 31
st
December
2014.
Art. 12. Financial Statements. Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the
manager or, as the case may be, the board of managers.
The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.
Art. 13. Distributions. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction
ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.
The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the manager,
or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood
128077
L
U X E M B O U R G
that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by
profits carried forward and distributable reserves and premium but decreased by losses carried forward and sums to be
allocated to a reserve to be established by law.
The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal
reserve account.
Art. 14. Dissolution. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators
who may be but do not need to be shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders who will
specify their powers and remunerations.
Art. 15. Sole Shareholder. If, and as long as one shareholder holds all the shares of the Company, the Company shall
exist as a single shareholder company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10
th
August 1915 on commercial com-
panies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.
Art. 16. Applicable law. For anything not dealt with in the present articles of association, the shareholders refer to the
relevant legislation.
<i>Subscription and paymenti>
The articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the appearing party has
subscribed and entirely paid-up the following shares:
Subscriber
Number
of shares
Subscription
price (EUR)
Dominium Pledgeco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
EUR 12,500
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
EUR 12,500
Evidence of the payment of the total subscription price has been shown to the undersigned notary.
<i>Expenses, Valuationi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately one thousand four hundred Euros (EUR 1,400).
<i>Extraordinary general meetingi>
The sole shareholder has forthwith taken immediately the following resolutions:
1. The registered office of the Company is fixed at: 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
2. The following person is appointed manager of the Company for an undetermined period of time subject to the
articles of association of the Company with such signature powers as set forth in the articles of association of the Company:
- BRE/Management 7 S.A., a société anonyme incorporated under the laws of Luxembourg, with registered office at
2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg and being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in
Luxembourg under number B 180.304.
Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day before mentioned.
The document having been read to the appearing party, who requested that the deed should be documented in English,
the said appearing party signed the present original deed together with the notary, having personal knowledge of the
English language. The present deed, worded in English, is followed by a translation into German. In case of divergences
between the English and the German text, the English version will prevail.
The document having been read to the appearing party, known to the notary by its name, first name, civil status and
residence, the said appearing party signed together with the notary the present deed.
Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:
Im Jahre zweitausendvierzehn, am einundzwanzigsten Tag des Monats Juli,
Vor dem unterzeichnenden Notar Maître Cosita Delvaux, mit Amtssitz in Redange-sur-Attert, Großherzogtum Lu-
xemburg,
ist erschienen,
Dominium Pledgeco S.à r.l., eine société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) luxemburgi-
schen Rechts mit Sitz in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, deren Gesellschaftskapital zwölftausendfünfhundert
Euro (EUR 12.500) beträgt, und die gerade dabei ist im Registre de commerce et des sociétés in Luxemburg eingetragen
zu werden,
hier vertreten durch Fräulein Sandra Mohand-Oussaïd, Juristin, beruflich wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer pri-
vatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt am 17. Juli 2014 welche vorliegender Urkunde beigefügt ist um mit dieser bei der
Registrierungsbehörde eingereicht zu werden.
128078
L
U X E M B O U R G
Die erschienene Partei hat in ihrer vorgenannten Eigenschaft den unterzeichnenden Notar ersucht, die Gründungs-
satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) "Dominium Holdco S.à r.l." wie
folgt zu beurkunden.
Art. 1. Gesellschaftsname. Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen
"Dominium Holdco S.à r.l." (die "Gesellschaft") wird hiermit von der erschienenen Partei und allen Personen, die gege-
benenfalls zukünftig als Gesellschafter eintreten, gegründet. Die Gesellschaft wird durch vorliegende Satzung und durch
die entsprechende luxemburgische Gesetzgebung geregelt.
Art. 2. Gesellschaftszweck. Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen in jeder beliebigen Form an in-
und ausländischen Gesellschaften sowie jede andere Form von Investitionen, sowie den Erwerb durch Kauf, Zeichnung
oder andere Art und Weise wie Übertragung durch Verkauf oder Tausch von Finanzinstrumenten jeder Art und die
Verwaltung, Aufsicht und Entwicklung ihres Portfolios.
Die Gesellschaft kann ebenfalls alle Transaktionen welche sich auf direkten oder indirekten Erwerb von Grundbesitz,
Eigentum, und Grundbesitzrechte in Luxemburg oder im Ausland oder auf den Erwerb von Beteiligungen an Unternehmen
welche im Besitz von Grundrechten sind oder von Unternehmensbeteiligungen jedweder Form beziehen, durchführen
sowie die Verwaltung, Aufsicht und Entwicklung dieser Beteiligungen und dieses Vermögen ausführen.
Die Gesellschaft kann Bürgschaften geben, Sicherheiten leisten, Darlehen ausgeben oder die Gesellschaften an denen
die Gesellschaft direkte oder indirekte Beteiligungen besitzt oder die zur Gruppe von Gesellschaften gehört, der die
Gesellschaft angehört, in jeder anderen Form unterstützen.
Die Gesellschaft kann außerdem in jeder beliebigen Form Darlehen erwerben, auch mit Preisnachlass, Darlehen ver-
geben, Kapital verleihen, sowie Vorschüsse gewährleisten oder unter jeglichen Konditionen Kredite vergeben, einschließ-
lich und ohne Einschränkungen derer Kredite, in Bezug auf ein Immobilien-Unternehmen oder -Unterfangen, die sich von
jeglichen Kreditaufnahmen der Gesellschaft oder von der Ausgabe von Kapital oder Schuldtitel jeglicher Art an alle Per-
sonen und Unternehmen, für die es für richtig empfunden wurde, ergeben. Die Gesellschaft kann Swaps, Futures,
Forwards, derivative Instrumente, Optionen, Rückkäufe, Wertpapierverleihe und ähnliche Transaktionen abschließen und
unbeschadet der Allgemeingültigkeit des Vorstehenden, jegliche Methode und Instrumente im Zusammenhang mit ihren
Immobiliengeschäften einsetzen. Die Gesellschaft kann auch jegliche Verträge über Garantien, Entschädigungen, Sicher-
heiten und alle weiteren äquivalente Verträge abschließen, so dass der Nutzen der, im Rahmen solcher Immobilienge-
schäfte vergebenen, Garantien und/oder Sicherheiten ihr zu Gute kommen kann. Die Gesellschaft kann im Rahmen solcher
Immobiliengeschäfte jegliche erforderliche Rolle übernehmen, einschließlich und ohne Einschränkungen der Rolle des
Arranger, lead Manager, Facility Agent, Security Agent, Documentation Agent. Die Gesellschaft wird die Tätigkeit der
Immobilienfinanzierung oder des Immobilienkrediterwerbs nicht in einer Weise ausüben, die eine Regulierung erfordern
würde gemäß der geänderten Fassung des Gesetzes des 5. Aprils 1993 bezüglich des Finanzsektors oder jeglichen zu-
künftigen Gesetzes oder Regulierungsmaßnahme, die dieses Gesetz abändern oder ersetzen sollte.
Die Gesellschaft kann alle geschäftlichen, technischen, finanziellen ebenso wie alle andere direkt oder indirekt ver-
bundenen Tätigkeiten welche die Erfüllung des Geschäftszwecks in den oben genannten Bereichen erleichtern, vorneh-
men.
Unter anderem wird die Gesellschaft allen Gesellschaften ihres Portfolios die für die Verwaltung, Entwicklung und
Aufsicht dieser Gesellschaften notwendigen Leistungen zur Verfügung stellen. Für diesen Zweck kann die Gesellschaft die
Unterstützung anderer Berater beanspruchen und auf solche zurückgreifen.
Art. 3. Geschäftsdauer. Die Gesellschaft ist auf unbegrenzte Dauer gegründet.
Art. 4. Gesellschaftssitz. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg. Dieser kann,
durch Beschluss einer außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter die sich, in der für die Abänderung der
Satzung vorgesehenen Art und Weise beraten, an jeden Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.
Der eingetragene Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss des Geschäftsführers, beziehungsweise durch die Ge-
schäftsführung innerhalb der Gemeinde verlegt werden.
Die Gesellschaft kann Geschäfts- und Zweigstellen in Luxemburg und im Ausland errichten.
Sollte der Geschäftsführer, oder im Falle einer Geschäftsführung die Geschäftsführung, feststellen, dass außerordent-
liche politische, wirtschaftliche oder soziale Ereignisse eingetreten sind oder unmittelbar bevorstehen welche die
normalen Tätigkeiten der Gesellschaft an ihrem eingetragenen Sitz oder die problemlose Kommunikation zwischen die-
sem Sitz und Personen im Ausland beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zum
vollständigen Ende solcher ungewöhnlichen Umstände ins Ausland verlegt werden; derartige vorläufige Maßnahmen haben
keine Auswirkung auf die staatliche Zugehörigkeit der Gesellschaft, die unbeschadet einer solchen vorübergehenden
Sitzverlegung eine luxemburgische Gesellschaft bleibt. Solche vorübergehenden Maßnahmen werden vom Geschäftsführer
oder, im Falle einer Geschäftsführung, von der Geschäftsführung vorgenommen und jeglichen betroffenen Personen mit-
geteilt.
Art. 5. Gesellschaftskapital. Das ausgegebene Gesellschaftskapital der Gesellschaft beläuft sich auf zwölftausendfünf-
hundert Euro (EUR 12.500), eingeteilt in fünf hundert (500) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je fünfund-
zwanzig Euro (EUR 25).
128079
L
U X E M B O U R G
Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter in der für die Abänderung der
Satzung vorgesehenen Art und Weise erhöht oder verringert werden und die Gesellschaft kann seine anderen Gesell-
schaftsanteile durch Beschluss der Gesellschafter zurückkaufen.
Verfügbare Anteilsprämien können verteilt werden.
Art. 6. Übertragung der Anteile. Die Anteile sind unter den Gesellschaftern frei übertragbar. Soweit es das Gesetz
nicht anders bestimmt, bedarf die Übertragung von Anteilen auf Dritte der Einwilligung von Gesellschaftern, welche
zusammen mindestens fünfundsiebzig Prozent (75%) des Gesellschaftskapitals halten.
Art. 7. Geschäftsführung. Die Geschäftsführung der Gesellschaft erfolgt durch einen oder mehrere Geschäftsführer
die keine Gesellschafter sein müssen.
Im Falle mehrerer Geschäftsführer bilden diese die Geschäftsführung.
Der alleinige Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung ist mit den weitestreichenden Befugnissen aus-
gestattet, das Geschäft der Gesellschaft zu verwalten und ist dazu befugt, jede Handlungen und Tätigkeiten, die mit dem
Gegenstand der Gesellschaft im Einklang stehen, zu genehmigen und/oder auszuführen. Sämtliche Befugnisse, die nicht
ausdrücklich per Gesetz oder durch die vorliegende Satzung den Gesellschaftern vorbehalten sind, fallen in den Zustän-
digkeitsbereich des Geschäftsführers beziehungsweise der Geschäftsführung.
Gegenüber Dritten hat der Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung die weitestreichenden Befugnisse
um in allen Umständen, im Namen und Auftrag der Gesellschaft zu handeln und in jeden Umständen, jeden Akt und jede
Handlung, welche nicht durch die vorliegende Satzung oder durch die entsprechende luxemburgische Gesetzgebung im
Kompetenzbereich der Gesellschafterversammlung liegt, im Auftrag der Gesellschaft vorzunehmen, zu erlauben und gut-
zuheißen.
Die Geschäftsführer werden durch mehrheitlichen Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter gewählt und
abberufen, welche ihre Befugnisse und die Amtsdauer beschließt. Wenn keine Frist gesetzt wird, dann sind die Geschäfts-
führer auf unbestimmte Zeit ernannt. Die Geschäftsführer können wiedergewählt werden, jedoch kann ihre Ernennung
zu jeder Zeit mit oder ohne Grund (ad nutum) widerrufen werden.
Jeder Geschäftsführer kann an jeder Sitzung der Geschäftsführung teilnehmen mittels Telefonkonferenz oder anderen
zur Verfügung stehenden Kommunikationsmitteln insofern gewährleistet ist, dass alle an der Sitzung teilnehmenden Per-
sonen sich hören und miteinander kommunizieren können. Eine Sitzung kann jederzeit mittels einer Telefonkonferenz
oder ähnlichen Kommunikationsmitteln abgehalten werden. Die Teilnahme oder das Abhalten einer Sitzung mit Hilfe
dieser Mittel entspricht einer persönlichen Teilnahme an der betroffenen Sitzung. Die Geschäftsführer können sich in den
Sitzungen ohne Einschränkung der Anzahl der Vollmachten durch einen anderen Geschäftsführer, der hierzu bevoll-
mächtigt ist, vertreten lassen.
Die Geschäftsführer sind mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor Beginn einer Sitzung der Geschäftsführung
mittels schriftlicher Einberufung, zu benachrichtigen, außer in Notfällen, in welchem Fall die Art und die Gründe dieser
Umstände in der Einberufung erläutert werden müssen. Auf das Recht auf die oben beschriebene Weise einberufen zu
werden kann jeder Geschäftsführer durch schriftliche Zustimmung per Telegramm, Telekopie, Email, Telefax oder per
ähnlichem Kommunikationsmittel verzichten. Spezifische Einberufungen sind nicht notwendig für Sitzungen, welche vorher
zu einem durch Geschäftsführungsbeschluss genehmigten Zeitplan und zu vorgesehenen Zeiten und an vorbestimmten
Orten abgehalten werden.
Entscheidungen der Geschäftsführung werden durch die Mehrheit der Geschäftsführer der Gesellschaft gefasst.
Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden der Sitzung oder, in seiner Abwesenheit,
von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Protokolle werden vom Vorsitzenden oder von
zwei Geschäftsführern unterzeichnet.
Schriftliche Beschlüsse der Geschäftsführung können, aus einem einzigen oder mehreren einzelnen Dokumenten, gültig
abgeschlossen werden, wenn sie von allen Mitgliedern der Geschäftsführung schriftlich, per Telegramm, Telefax oder per
ähnlichem Kommunikationsmittel genehmigt wurden. Die verschiedenen Dokumente gleichen Inhalts bilden zusammen
einen gültigen schriftlichen Beschluss. Beschlüsse der Geschäftsführung, einschließlich schriftliche Beschlüsse, können von
einem einzelnen Geschäftsführer beweiskräftig beglaubigt und ein Auszug davon beweiskräftig unterschrieben werden.
Die Gesellschaft wird durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder durch die Unterschrift eines einzel-
nen Geschäftsführers im Falle einer Geschäftsführung gebunden. Die Gesellschaft ist in jedem Fall wirksam durch die
Unterschrift einer oder mehrerer hierzu durch den alleinigen Geschäftsführer, beziehungsweise durch die Geschäftsfüh-
rung oder einer der Geschäftsführer, bevollmächtigten Personen, gebunden.
Art. 8. Haftung der Geschäftsführung. Die Geschäftsführer sind für Verschuldung der Gesellschaft nicht persönlich
haftbar. Als Vertreter der Gesellschaft sind sie jedoch für die Ausführung ihrer Aufgaben und Pflichten verantwortlich.
Vorbehaltlich den unten aufgeführten Ausnahmen und Beschränkungen, wird jede Person, die ein Geschäftsführer oder
leitender Angestellter der Gesellschaft ist oder war, von der Gesellschaft in vollem, gesetzlich erlaubten, Umfang gegen
Verbindlichkeiten und gegen alle Ausgaben, welche üblicherweise entstanden sind oder von ihm gezahlt wurden in Ver-
bindung mit Klagen, Prozessen oder Verfahren in die er als Partei oder anderweitig eintritt aufgrund dessen, dass er ein
Geschäftsführer oder leitender Angestellter ist oder gewesen ist und die diesbezüglich gezahlten Beträge oder von durch
128080
L
U X E M B O U R G
deren Beilegung entstandenen Beträge, schadlos gehalten werden. Die Begriffe „Klage“, „Streitsache“, „Prozess“oder
„Verfahren“finden auf alle anhängigen oder bevorstehenden Klagen, Streitsachen, Prozesse oder Verfahren Anwendung
(zivilrechtlich, strafrechtlich oder sonstige, einschließlich Rechtsmittel) Anwendung und die Begriffe „Verbindlichkeit“und
„Ausgaben“beinhalten ohne Beschränkung Anwaltskosten, Prozesskosten, Sicherheitsleistungen, gezahlte Beträge bei
Streitbeilegung und andere Verbindlichkeiten.
Einem Geschäftsführer oder leitendem Angestellten wird keine Schadloshaltung gewährt:
(i) gegen Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschaft oder ihrer Gesellschafter, aufgrund von vorsätzlich begangenen
unerlaubten Handlungen, Bösgläubigkeit, grober Fahrlässigkeit oder rücksichtsloser Missachtung der Aufgaben, die in
seiner Amtsführung enthalten sind;
(ii) im Zusammenhang mit jeglichen Verfahren bei welchen er wegen bösgläubigem und nicht im Interesse der Gesell-
schaft erfolgtem Handeln, verurteilt wurde; oder (iii) im Falle einer Beilegung, es sei denn die Beilegung ist von einem
Gericht unter zuständiger Gerichtsbarkeit oder von der Geschäftsführung genehmigt worden.
Das Recht der Schadloshaltung, das hier vorgesehen ist, ist abtrennbar und berührt keine anderen Rechte auf die das
Verwaltungsratsmitglied oder der leitende Angestellte jetzt oder später ein Anrecht hat, und soll fortgeführt werden in
der Person, die aufgehört hat, ein Geschäftsführer oder leitender Angestellter zu sein und soll dem Vorteil der Erben,
Testamentsvollstreckern und Verwaltern einer solchen Person dienen. Nichts hierin Enthaltenes berührt die Rechte zur
Schadloshaltung, auf die Gesellschaftspersonal, eingeschlossen Geschäftsführer und leitende Angestellte, aufgrund von
Vertrag oder anderweitig durch Gesetz, Anspruch haben könnten.
Ausgaben in Verbindung mit Vorbereitung und Vertretung der Verteidigung einer Klage, Streitsache, Prozess oder
Verfahren beschrieben in diesem Artikel, soll von der Gesellschaft vor der endgültigen Verfügung darüber bei Zugang
jeglicher Unternehmung seitens oder im Namen eines leitenden Angestellten oder Geschäftsführers vorgestreckt werden,
um den benannten Betrag zurückzuzahlen wenn es letztlich bestimmt ist, dass er keinen Anspruch auf Schadloshaltung
unter diesem Artikel hat.
Art. 9. Stimmrechte der Gesellschafter. Jeder Gesellschafter kann an kollektiven Entscheidungen teilnehmen. Die Zahl
seiner Stimmen entspricht der Zahl seiner Gesellschaftsanteile und der Gesellschafter kann bei jeder Versammlung durch
eine spezielle Vollmacht vertreten werden.
Art. 10. Gesellschafterversammlungen. Die Beschlüsse der Gesellschafter werden in der im luxemburgischen Gesell-
schaftsrecht vorgeschriebenen Form und mit der darin vorgesehenen Mehrheit, schriftlich (soweit dies gesetzlich möglich
ist) oder in Gesellschafterversammlungen, gefasst. Jede ordnungsgemäß konstituierte Gesellschafterversammlung der
Gesellschaft beziehungsweise jeder ordnungsgemäß schriftlicher Beschluss vertritt die Gesamtheit der Gesellschafter der
Gesellschaft.
Die Einberufung der Versammlungen durch den Geschäftsführer/die Geschäftsführung hat mindestens acht (8) Tage
vor der Versammlung mittels eingeschriebenen Briefes an die Gesellschafter an ihre im Anteilsregister der Gesellschaft
eingetragene Adresse, zu erfolgen. Wenn das gesamte Gesellschaftskapital der Gesellschaft vertreten ist, kann die Sitzung
ohne vorherige Einberufung abgehalten werden.
Werden Beschlüsse im Wege eines Zirkularbeschlusses der Gesellschafter gefasst, so wird der Inhalt des Beschlusses
mindestens acht (8) Tage bevor der Beschluss wirksam werden soll, an alle Gesellschafter an ihre im Anteilsregister
eingeschriebene Adresse mittels eingeschriebenen Briefs übersandt. Die Beschlüsse werden wirksam bei Zustimmung
der vom Gesetz vorgesehenen Mehrheiten für gemeinsame Entscheidungen (oder, unter der Voraussetzung der Befrie-
digung der Mehrheitsvoraussetzungen, am in dieser Entscheidung festgelegten Tag). Einstimmige Zirkularbeschlüsse
können jederzeit ohne vorherige Ankündigung getroffen werden.
Soweit gesetzlich nichts anderes vorgesehen ist, (i) werden die in den Gesellschafterversammlungen zu fassenden
Beschlüsse von den Gesellschaftern getroffen, welche mehr als die Hälfte des Geschäftskapitals vertreten. Wird eine
solche Mehrheit bei der ersten Gesellschafterversammlung nicht erreicht, werden die Gesellschafter per Einschreiben zu
einer zweiten Gesellschafterversammlung geladen und die Beschlüsse werden sodann aufgrund der Mehrheit der abge-
gebenen Stimmen gefasst, unbeschadet der Anzahl der vertretenen Geschäftsanteile. (ii) Die Satzung kann jedoch nur mit
Zustimmung (x) der Mehrheit der Gesellschafter, welche (y) zwei Drittel des Gesellschaftskapitals vertreten, abgeändert
werden und (iii) Entscheidungen, die Nationalität der Gesellschaft zu ändern, bedürfen der Zustimmung von Gesellschaf-
tern, die einhundert Prozent (100%) des Gesellschaftskapitals vertreten.
Zu keiner Zeit soll die Gesellschaft mehr als dreißig (30) Gesellschafter haben. Zu keiner Zeit soll es einer natürlichen
Person gestattet sein, ein Gesellschafter der Gesellschaft zu werden.
Art. 11. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten (1.) Januar und endet am einunddreißigsten (31.) Dezember
eines jeden Jahres. Das erste Geschäftsjahr, welches am Tage der Gründung der Gesellschaft beginnt, wird am 31. De-
zember 2014 enden.
Art. 12. Jahresabschluss. Der alleinige Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung erstellt jedes Jahr die
Jahresabrechnung der Gesellschaft.
Jeder Gesellschafter kann die Jahresabrechnung am Sitz der Gesellschaft einsehen.
128081
L
U X E M B O U R G
Art. 13. Gewinnverwendung. Fünf Prozent (5%) des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft werden der gesetzlich
vorgeschriebenen Rücklage zugeführt. Diese Rücklageeinzahlungspflicht besteht nicht mehr, sobald die gesetzliche Rück-
lage zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.
Die Gesellschafter können auf der Grundlage eines von dem alleinigen Geschäftsführer, beziehungsweise der Ge-
schäftsführung angefertigten Zwischenabschlusses die Ausschüttung von Abschlagsdividenden beschließen, sofern dieser
Zwischenabschluss zeigt, dass ausreichend Gewinne und andere Reserven zur Ausschüttung zur Verfügung stehen, wobei
der auszuschüttende Betrag die seit dem Ende des vorhergehenden Geschäftsjahres erzielten Gewinne, für welches die
Jahresabschlüsse bereits bewilligt wurden, erhöht um die vorgetragenen Gewinne und ausschüttbaren Rücklagen, ver-
mindert um die vorgetragenen Verluste und die der gesetzlichen Rücklage zuzuführenden Beträge, nicht übersteigen darf.
Der Saldo kann nach Entscheidung der Gesellschafterversammlung an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.
Das Anteilsprämienkonto kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung an die Gesellschafter ausgeschüttet
werden. Die Gesellschafterversammlung kann beschließen, jeden Betrag vom Anteilsprämienkonto auf die gesetzliche
Rücklage zu übertragen.
Art. 14. Auflösung. Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft ernennen die Gesellschafter einen oder mehrere Liqui-
datoren, bei welchen es sich nicht um Gesellschafter handeln muss, zwecks der Durchführung der Auflösung und
bestimmen ihre Befugnisse und Vergütung.
Art. 15. Alleingesellschafter. Sofern nur ein Gesellschafter alle Geschäftsanteile der Gesellschaft hält, gilt Artikel 179
(2) des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften und die Artikel 200-1 und 200-2 finden u.a. Anwendung.
Art. 16. Anwendbares Recht. Sämtliche nicht ausdrücklich durch diese Satzung geregelten Angelegenheiten richten
sich nach den entsprechenden Regelungen des anwendbaren Gesetzes.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Nach dem die erschienene Partei die Gründungssatzung erstellt hat, hat sie das gesamte Gesellschaftskapital wie folgt
eingezahlt und gezeichnet:
Einzahler
Zahl der
Geschäftsanteile
Einzahlungspreis
(EUR)
Dominium Pledgeco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
EUR 12.500
Summe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
EUR 12.500
Ein Beleg für die vollständige Einzahlung der Geschäftsanteile wurde dem unterzeichneten Notar vorgelegt.
<i>Kostenschätzungi>
Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund der vorlie-
genden Gesellschaftsgründung entstehen, werden auf ungefähr vierzehnhundert Euro (EUR 1.400) geschätzt.
<i>Ausserordentliche Beschlüsse des Gesellschaftersi>
Unverzüglich nach der Gründung der Gesellschaft hat der Alleinige Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:
1. Sitz der Gesellschaft ist in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg.
2. Die folgende Person wird für einen unbeschränkten Zeitraum zum Geschäftsführer der Gesellschaft mit der in der
Satzung der Gesellschaft beschriebenen Unterschriftsbefugnis ernannt:
- BRE/Management 7 S.A., eine Aktiengesellschaft (société anonyme) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 2-4, rue
Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg und eingetragen im Registre de Commerce et des Sociétés in Luxemburg unter der
Nummer B 180.304.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnende Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass auf Ersuchen der oben erschie-
nenen Partei, die vorliegende Urkunde in English abgefasst wird, gefolgt von einer deutschen Übersetzung.
Auf Ersuchen derselben erschienenen Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deut-
schen Text, ist die englische Fassung maßgebend.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die erschienene Partei die dem amtierenden Notar nach
Namen, Vornamen, Zivilstand und Wohnort bekannt, hat dieselbe zusammen mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.
Gezeichnet: S. MOHAND-OUSSAID, C. DELVAUX.
Enregistré à Redange/Attert, le 24 juillet 2014. Relation: RED/2014/1631. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): T. KIRSCH.
FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum
Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
128082
L
U X E M B O U R G
Redange-sur-Attert, den 24. Juli 2014.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2014117143/452.
(140135371) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2014.
X-Rite Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 36.754,00.
Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.
R.C.S. Luxembourg B 152.208.
ln the year two thousand and fourteen, on the twenty-second day of July.
Before Us, Maître Marc Lecuit, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Launchchange Holding Company, a private unlimited company existing under the laws of England and Wales, with its
registered office at Suite 31, The Quadrant, 99 Parkway Avenue, Parkway Business Park, Sheffield, South Yorkshire S9
4WG, United Kingdom, registered with the Companies House for England and Wales under company number 03259276
(the "Sole Shareholder"),
Hereby represented by Mr. Faruk Durusu, avocat à la Cour, with professional address at 33, rue du Puits Romain,
L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.
The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
(i) that it is the current sole shareholder of X~Rite Holdings S,à roi., a société à responsabilité limitée unipersonnelle,
organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 33, rue du Puits Romain,
L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under
the number 8152208, established in Luxembourg by a notarial deed of Maître Marc Lecuit, notary residing in Mersch, on
March 24
th
, 2010, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations number 930 of May 4
th
,
2010, of which the articles have been amended several times and for the last time pursuant to a notarial deed of the
undersigned notary dated February 13
th
, 2014, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations
number 935 of April 11
th
, 2014.
(i) That the Sole Shareholder is the sole legal and beneficial owner of ail the issued and outstanding shares (the "Shares")
of Videojet Technologies Suisse GmbH, a Swiss private limited company with its registered office at Gummertlistrasse 7,
Gewerbe Ost, 4702 Oensingen, Switzerland and being registered with the Commercial Register of the Canton of Solo-
thurn under number CHE-11 0.177.534 ("Videojet");
(ii) That, as payment in full for one (1) new ordinary share with a nominal value of ninety-four United States dollars
(USD 94.-) in the share capital of the Company (the "New Share") and a global share premium in the amount of twelve
million fifty-eight thousand nine hundred thirty-eight United States dollars (USD 12,058,938) (the "Share Premium"), the
Sole Shareholder wishes to make, with effect as of the date of the present deed, a contribution in kind to the Company
consisting of the Shares;
(iii) That the Company wishes to accept the Shares in consideration for the issuance of the New Share and the Share
Premium;
(iv) That the Sole Shareholder has waived any convening notice right and has therefore adopted the following reso-
lutions.
<i>First resolutioni>
It is resolved to increase, with effect as of the signature of the present deed (acte notarié), the share capital of the
Company by an amount of ninety-four United States dollars (USD 94.-) so as to raise it from its current amount of thirty-
six thousand six hundred and sixty United States dollars (USD 36,660.-) to thirty-six thousand seven hundred and fifty-
four United States dollars (USD 36,754) by the issue of one (1) new ordinary share with a nominal value of ninety-four
United States dollars (USD 94.-), subject to the payment of the Share Premium, the whole to be fully paid up through a
contribution in kind by the Sole Shareholder to the Company consisting of the Shares (the "Contribution").
<i>Second resolutioni>
It is resolved to accept the subscription and the payment by the Sole Shareholder of the New Share and of the Share
Premium by a contribution in kind consisting of the Shares.
<i>Contributors' intervention - Subscription - Paymenti>
Thereupon intervened the Sole Shareholder duly represented by Mr. Faruk Durusu, before named, and he declared
to subscribe the New Share.
128083
L
U X E M B O U R G
<i>Description of the contributioni>
The total aggregate value of the Shares is twelve million fifty-nine thousand thirty-two United States dollars (USD
12,059,032).
The value of the Shares has been approved by a certificate of valuation issued by the Sole Shareholder dated 22 July
2014. Such valuation has been accepted though a statement on contribution value issued by the Company's managers and
dated July 22
nd
, 2014. This certificate of valuation and the statement on contribution value shall remain annexed to the
present deed and submitted with it to the formality of registration.
<i>Evidence of the contribution's existencei>
A proof of the Contribution's existence has been given to the undersigned notary.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the foregoing statements and resolutions, and the contribution having been fully carried out, the
shareholding of the Company shall be composed of:
- Launchchange Holding Company: three hundred ninety-one (391) ordinary shares.
<i>Fourth resolutioni>
As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the contribution having been fully carried out, It is
resolved to amend the first phrase of article 7 of the Company's articles of association, which shall then be read as follows:
" Art. 7. The issued capital of the Company is set at thirty-six thousand seven hundred and fifty-four United States
dollars (USD 36,754) represented by three hundred ninety-one (391) shares with a nominal value of ninety-four United
States dollars (USD 94.-), ail of which are fully subscribed and paid up.".
<i>Estimate of Costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Sole Shareholder or which
shall be charged to It in connection with the present deed, have been estimated at about five thousand Euro (EUR 5,000).
There being no further business, the meeting is closed.
The undersigned notary, who knows Engllsh, states thaï on request of the appearing party, the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Beringen, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, it signed together with the notary the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quatorze, le vingt-deux juillet.
Par-devant Maitre Marc Lecuit, notaire de résidence à Mersch.
A COMPARU:
Launchchange Holding Company, une société privée à responsabilité illimitée régie par les lois d'Angleterre et du Pays
de Galle, ayant son siège social au Suite 31, The Quadrant, 99, Parkway Avenue, Parkway Business Park, Sheffield S9 4WG,
South Yorkshire, Royaume-Uni, inscrite au registre des sociétés pour le Royaume-Uni et le Pays-de-Galle sous le numéro
03259276 (l’«Associée Unique)»),
Ici représentée par Maitre Faruk Durusu, avocat à la Cour, demeurant professionnellement au 33, rue du Puits Romain,
L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé à lui délivrée.
Ladite procuration restera, après avoir été signée "ne varietur' par la comparante et le notaire instrumentant, annexée
aux présentes pour être enregistrée avec elle.
La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
(i) Qu'elle est l’unique et actuelle associée de la société X-Rite Holdings S.à r.L, société à responsabilité limitée uni-
personnelle, ayant son siège social au 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg,
immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 152208, établie suivant acte
notarié reçu par Maître Marc LECUIT, notaire de résidence à Mersch, en date du 24 mars 2010, publié au Mémorial C,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 930 du 4 mai 2010, dont les statuts ont été modifiés à plusieurs
reprises et pour la dernière fois suivant acte notarié reçu par le notaire soussigné du 13 février 2014, publié au Mémorial
C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 935 du 11 avril 2014.
(i) Que l’Associée Unique est le seul détenteur légal et économique de toutes les parts sociales (les "Parts") de Videojet
Technologies Suisse GmbH, une société à responsabilité limitée de droit suisse, établie et ayant son siège social au 7
Gummertlistrasse 7, Gewerbe Ost, 4702 Oensingen, Suisse, inscrite au registre de commerce du Canton de Solothurn
sous le numéro CHE-110.177.534 ("Videojet");
128084
L
U X E M B O U R G
(ii) Que pour la libération de la totalité d'une (1) part sociale nouvelle d'une valeur nominale de quatre-vingt-quatorze
dollars américains (94 USD) dans le capital social de la Société (la «Nouvelle Part)») et une prime d'émission global d'un
montant de douze millions cinquante huit mille neuf cent trente-huit dollars américains (12.058.938 USD) (la (( Prime
d'Emission)»), l’Associée Unique souhaite, avec effet à la date du présent acte, faire un apport en nature des Parts à la
Société;
(iii) Que la Société désire accepter les Parts contre l’émission de la Nouvelle Part et la Prime d'Emission; et
(iv) Que l’Associée Unique a renoncé à tout droit de convocation préalable et a partant adopté les résolutions suivantes.
<i>Première résolutioni>
Il est décidé d'augmenter, avec effet à compter de la signature du présent acte notarié, le capital social de la Société,
d'un montant de quatre-vingt quatorze dollars américains (94 USD) afin de le porter de son montant actuel de trente-
six mille six cent soixante dollars américains (36.660 USD) à trente-six mille sept cent cinquante-quatre dollars américains
(36.754 USD) par l’émission d'une (1) nouvelle part sociale, sujette au paiement de la Prime d'Emission, le tout devant
être entièrement libéré par un apport en nature de l’Associée Unique des Parts à la Société (l'«Apport»).
<i>Deuxième résolutioni>
Il est décidé d'accepter la souscription et le paiement par l’Associée Unique de la Nouvelle Part et de la Prime d'Emission
par un apport en nature des Parts.
<i>Intervention des Apporteurs - Souscription - Paiementi>
Intervient ensuite l’Associée Unique dûment représentée par Maître Faruk Durusu, pré-désigné, qui déclare souscrire
à la Nouvelle Part.
<i>Description de l’apporti>
La valeur d'ensemble totale des Parts s'élève à douze millions cinquante neuf mille trente-deux dollars américains
(12.059.032 USD).
La valeur des Parts a été approuvée au moyen d'un certificat de valeur émis par l’Associée Unique et daté du 22 juillet
2014. Cette valorisation a été acceptée par les gérants de la Société conformément à une déclaration sur la valeur de
l’apport datée du 22 juillet 2014. Ce certificat de valeur et la déclaration sur la valeur de l’apport resteront annexés au
présent acte notarié pour être soumise aux formalités d'enregistrement avec lui.
<i>Preuve de l’existence de l’apporti>
Une preuve de l’existence de l’Apport a été fournie au notaire soussigné.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence des déclarations et résolutions qui précèdent, l’actionnariat de la Société est maintenant composé de:
- Launchchange Holding Company: trois cent quatre-vingt-onze (391) parts sociales ordinaires.
<i>Quatrième résolutioni>
En conséquence des déclarations et résolutions qui précèdent, l’apport étant totalement réalisé, il est décidé de mo-
difier la première phrase de l’article des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:
" Art. 7. Le capital social émis de la Société est fixé à trente six mille sept cent cinquante-quatre dollars américains
(36.754,- USD) représenté par trois cent quatre-vingt-onze (391) parts sociales d'une valeur nominale de quatre-vingt-
quatorze dollars américains (94,- USD) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées."
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à "Associé
Unique ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte s'élève à environ cinq mille euros (EUR 5.000).
Plus rien n'étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante,'a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Beringen, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: F. DURUSU, M. LECUIT.
Enregistré à Mersch, le 25 juillet 2014. Relation: MER/2014/1567. Reçu soixante quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): E. WEBER.
POUR COPIE CONFORME.
128085
L
U X E M B O U R G
Beringen, le 29 juillet 2014.
Référence de publication: 2014115766/157.
(140134930) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2014.
Eurasian Resources Group, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 62.500,00.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.
R.C.S. Luxembourg B 177.275.
In the year two thousand fourteen, on the twenty-second day of July,
before Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,
was held
an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of Eurasian Resources Group, a private limited
liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under Luxembourg law, having its registered
office at 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register
of Commerce and Companies under number B 177.275 and having a share capital of EUR 62,500.- (the Company).
THERE APPEARED
1. Eleanore Luxembourg II S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated
and existing under Luxembourg law, having its registered office at 179, route d'Arlon, L-8011 Strassen, Grand Duchy of
Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies (RCS) under number B 177.684
and having a share capital of USD 950,000.- (the Shareholder 1),
hereby represented by Mrs. Sophie Henryon, private employee, residing professionally in Esch-sur-Alzette, Grand
Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;
2. Silverfjord Holding S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and
existing under Luxembourg law, having its registered office at 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, registered with the RCS under number B 161.137 and having a share capital of EUR 12,500.- (the
Shareholder 2),
hereby represented by Mrs. Sophie Henryon, private employee, residing professionally in Esch-sur-Alzette, Grand
Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;
3. ALM Management S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and
existing under Luxembourg law, having its registered office at 22, avenue Marie Thérèse, L-2132 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, registered with the RCS under number B 161.139 and having a share capital of EUR 12,500.- (the
Shareholder 3),
hereby represented by Mrs. Sophie Henryon, private employee, residing professionally in Esch-sur-Alzette, Grand
Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;
4. Committee of the State Property and Privatisation of the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan, a legal
entity incorporated in the form of a state agency, having its registered office 11, Pobeda Avenue, KAZ-010000 Astana,
the Republic of Kazakhstan, acting on behalf of the Government of the Republic of Kazakhstan (the Shareholder 4, together
with the Shareholder 1, the Shareholder 2 and the Shareholder 3, the Shareholders),
hereby represented by Mrs. Sophie Henryon, private employee, residing professionally in Esch-sur-Alzette, Grand
Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;
After signature ne varietur by the authorised representative of the relevant Shareholder and the undersigned notary,
each power of attorney will remain attached to this deed to be registered with it.
The Shareholders, represented as set out above, have requested the undersigned notary to record the following:
I. That the Shareholders are the Company's sole shareholders and that the Meeting is thus validly constituted and may
deliberate on the items on the agenda, as set out below;
II. That the Company was incorporated on May 13, 2013 pursuant to a deed drawn up by Maître Francis Kesseler,
notary then residing in Esch-sur-Alzette, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Mémorial)
number 1609 of May 7, 2013. Since that date, the Company's articles of association (the Articles) have been amended
several times, most recently on June 24, 2013 pursuant to a deed of Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-
Alzette, published in the Mémorial number 2789 of July 17, 2013;
III. That the Meeting will resolve upon the following agenda:
1. Amendment and restatement of article 14 paragraph a) of the Articles.
2. Insertion of a new article 23 in the Articles.
IV. That the Meeting has taken the following resolutions:
128086
L
U X E M B O U R G
<i>First resolutioni>
The Shareholders resolve to amend and restate article 14 paragraph a) of the Articles, which will henceforth read as
follows:
“a) The variation, creation, increase, re-organisation, consolidation, sub-division, conversion, reduction, redemption,
repurchase, re-designation or other alteration of the authorised or issued shares or loan capital (for the avoidance of
doubt, any loan granted by a third party to the company or any Group Company does not constitute a loan capital and
does not fall under the scope of this article 14) of any Group Company or the variation, modification, abrogation or grant
of any rights attaching to any such shares or intergroup loans except as otherwise agreed by the shareholders from time
to time.
The entry into or creation by a Group Company of any agreement, arrangement or obligation requiring the creation,
allotment, issue, sale, disposal, encumbering of, redemption or repayment of, or the grant to a person of the right (con-
ditional or not) to require the creation, allotment, issue, sale, disposal, encumbering of, redemption or repayment of, a
share in the capital of any Group Company (including an option or right of pre-emption or conversion) except as otherwise
agreed by the shareholders from time to time.
The reduction, capitalisation, repayment or distribution of any amount standing to the credit of the share capital, share
premium account, capital redemption reserve or any other reserve of any Group Company, or the reduction of any
uncalled liability in respect of partly paid shares of a Group Company.”
<i>Second resolutioni>
The Shareholders resolve to insert a new article 23 in the Articles, which will read as follows:
“ Art. 23. These articles of association are worded in English followed by a French version. In case of discrepancies
between the English and the French text, the English version shall prevail.”
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the Shareholders, this deed
is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of discrepancies, the English text prevails.
This notarial deed is drawn up in Esch-sur-Alzette, on the date stated above.
After reading this deed aloud, the notary signs it with the Shareholders' authorised representative.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quatorze, le vingt-deux juillet,
par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est tenue
une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de Eurasian Resources Group, une société à res-
ponsabilité limitée régie et existant sous le droit du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 9, rue Sainte
Zithe, L-2763 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 177.275 et ayant un capital social de EUR 62.500.- (la Société).
ONT COMPARU
1. Eleanore Luxembourg II S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie et existant sous le droit du Grand-Duché
de Luxembourg, ayant son siège social au 179, route d'Arlon, L-8011 Strassen, Grand-Duché de Luxembourg, immatri-
culée au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg (RCS) sous le numéro B 177.684 et ayant un capital social
de USD 950,000.- (l'Associé 1),
ici représentée par Mme. Sophie Henryon, employée privée, avec adresse professionnelle à Esch-sur-Alzette, Grand-
Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé;
2. Silverfjord Holding S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie et existant sous le droit du Grand-Duché de
Luxembourg, ayant son siège social au 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
immatriculée au RCS sous le numéro B 161.137 et ayant un capital social de EUR 12,500.- (l'Associé 2),
ici représentée par Mme. Sophie Henryon, employée privée, avec adresse professionnelle à Esch-sur-Alzette, Grand-
Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé;
3. ALM Management S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie et existant sous le droit du Grand-Duché de
Luxembourg, ayant son siège social au 22, avenue Marie Thérèse, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
immatriculée au RCS sous le numéro B 161.139 et ayant un capital social de EUR 12,500.- (l'Associé 3),
ici représentée par Mme. Sophie Henryon, employée privée, avec adresse professionnelle à Esch-sur-Alzette, Grand-
Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé;
4. Committee of the State Property and Privatisation of the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan, une
entité légale constituée sous la forme d'une agence d'Etat, ayant son siège social au 11 Pobeda Avenue, Astana 010000,
128087
L
U X E M B O U R G
République du Kazakhstan, agissant au nom et pour le compte du gouvernement de la République du Kazakhstan (l'Associé
4 et, ensemble avec l'Associé 1, l'Associé 2 et l'Associé 3, les Associés),
ici représentée par Mme. Sophie Henryon, employée privée, avec adresse professionnelle à Esch-sur-Alzette, Grand-
Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.
Après avoir été signées ne varietur par le mandataire de l'Associé en question et le notaire instrumentant, chaque
procuration restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.
Les Associés, représentés comme indiqué ci-dessus, ont prié le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Que les Associés sont les seuls associés de la Société et que l'Assemblée est dès lors régulièrement constituée et
peut délibérer sur les points de l'ordre du jour reproduits ci-après;
II. Que la Société a été constituée le 13 mai 2013, suivant acte reçu par Maître Francis Kesseler, notaire de résidence
à Esch-sur-Alzette, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le Mémorial) numéro 1609 du 17 mai
2013. Depuis cette date, les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés à plusieurs reprises et le plus récemment
le 24 juin 2013, suivant acte reçu par Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de
Luxembourg, publié au Mémorial numéro 2789 du 17 juillet 2013;
III. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Modification et reformulation du paragraphe a) de l'article 14 des Statuts.
2. Introduction d'un nouvel article 23 dans les Statuts.
IV. Que l'Assemblée a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les Associés décident de modifier et reformuler le paragraphe a) de l'article 14 des Statuts, de sorte qu'il aura doré-
navant la teneur suivante:
“a) la modification, création, augmentation, réorganisation, consolidation, sous-division, conversion, réduction, rachat,
remboursement, renomination ou autre modification des parts sociales autorisées ou émises ou «loan capital» (afin
d'éviter toute incertitude, tout prêt accordé par une partie tierce à la société ou à toute Société du Groupe ne constitue
pas un «loan capital» et ne tombe pas dans le champ d'application de cet article 14) de toute Société du Groupe ou la
variation, modification, abrogation ou l'attribution de droits attachés à ces actions ou prêts intragroupes sauf autrement
consenti par les associés à tout moment.
La conclusion ou la création par une Société du Groupe de tout contrat, arrangement ou obligation requérant la
création, attribution, émission, vente, cession, nantissement, rachat, remboursement ou l'attribution de droits (condi-
tionnelle ou non) de requérir la création, l'attribution, l'émission, la vente, la cession, le nantissement, le rachat ou le
remboursement d'une action dans le capital de toute Société du Groupe (incluant une option, un droit de préemption
ou conversion) sauf autrement consenti par les associés en tout moment.
La réduction, capitalisation, remboursement ou la distribution de tout montant au capital social, compte de prime
d'émission, réserve de rachat de capital ou tout autre réserve de toute Société du Groupe, ou la réduction de l'engagement
non appelé relatif à des actions partiellement libérées d'une Société du Groupe.”
<i>Deuxième résolutioni>
Les Associés décident d'introduire un nouvel article 23 dans les Statuts, qui aura la teneur suivante:
“ Art. 23. Les présents statuts sont rédigés en anglais suivi d'une version française. En cas de divergences entre le texte
anglais et français, la version anglais prévaudra.”
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande des Associés, le présent acte est rédigé
en anglais, suivi d'une version française et que, en cas de divergences, la version anglaise fait foi.
Dont Acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, à la date qu'en tête des présentes.
Après avoir lu le présent acte à voix haute, le notaire le signe avec le mandataire des Associés.
Signé: Henryon, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 24 juillet 2014. Relation: EAC/2014/10357. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. Halsdorf.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2014117190/156.
(140135395) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2014.
128088
L
U X E M B O U R G
Energreen Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.
R.C.S. Luxembourg B 162.640.
RECTIFICATIF
<i>Extraiti>
Au lieu de:
Il résulte de plusieurs contrats de cessions signés en date du 18 avril 2014 que des parts sociales de la société GLO-
BALINK VENTURE LIMITED, ont été cédées à différentes sociétés. La nouvelle répartition se fera comme suit:
- 600 parts sociales à la société Energos International Corp., immatriculée auprès du Registre de Commerce de Panama,
sous le numéro 797562-2349835 et ayant son siège social au P.H. Plaza Commercial San Fernando, 1
st
Floor, office n.
41, Avenida Central Via Espana, Panama, République de Panama;
- 629 parts sociales à la société S.C.P. NKY, immatriculée auprès du Registre de Commerce de Monaco, sous le numéro
14 SC16566 et ayant son siège social au 5bis, Avenue Princesse Alice, MC-98000 Monaco;
- 410 parts sociales à la société S.C.P. LEL, immatriculée auprès du Registre de Commerce de Monaco, sous le numéro
14 SC16544 et ayant son siège social au 17, Boulevard du Larvotto, MC-98000 Monaco;
- 600 parts sociales à la société S.C.P. TIKI, immatriculée auprès du Registre de Commerce de Monaco, sous le numéro
14 SC16543 et ayant son siège social au 19, Boulevard de Suisse, MC-98000 Monaco;
- 791 parts sociales à la société S.C.P. GLG INVESTMENTS, immatriculée auprès du Registre de Commerce de Monaco,
sous le numéro 14 SC16542 et ayant son siège social au 17, Boulevard Princesse Charlotte, MC-98000 Monaco;
- 629 parts sociales à la société S.C.P. NABILA HK, immatriculée auprès du Registre de Commerce de Monaco, sous
le numéro 14 SC16567 et ayant son siège social au 5bis, Avenue Princesse Alice, MC-98000 Monaco;
- 600 parts sociales à la société SILVER BULLET FUND Ltd, immatriculée auprès du Registre de Commerce de Kuala
Lumpur, sous le numéro LL07034 et ayant son siège social au 16
th
Floor, Menara MIDF, Kuala Lumpur, 50200 Malaisie;
- 908 parts sociales à la société 3C Investments Limited, immatriculée auprès du Registre de Commerce de Hong
Kong, sous le numéro 1813738 et ayant son siège social au Unit 2301, Fook Lee Commercial Centre, Town Place, 33
Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong.
La société GLOBALINK VENTURE LIMITED détient désormais 2.860 parts sociales de la société Energreen Investment
S.à.r.l.
Il y a lieu de lire:
Il résulte de plusieurs contrats de cessions signés en date du 18 avril 2014 que des parts sociales de la société GLO-
BALINK VENTURE LIMITED, ont été cédées à différentes sociétés. La nouvelle répartition se fera comme suit:
- 600 parts sociales à la société Energos International Corp., immatriculée auprès du Registre de Commerce de Panama,
sous le numéro 797562-2349835 et ayant son siège social au P.H. Plaza Commercial San Fernando, 1
st
Floor, office n.
41, Avenida Central Via Espana, Panama, République de Panama;
- 629 parts sociales à la société S.C.P. NKY, immatriculée auprès du Registre de Commerce de Monaco, sous le numéro
14 SC16566 et ayant son siège social au 5bis, Avenue Princesse Alice, MC-98000 Monaco;
- 410 parts sociales à la société S.C.P. LEL, immatriculée auprès du Registre de Commerce de Monaco, sous le numéro
14 SC16544 et ayant son siège social au 17, Boulevard du Larvotto, MC-98000 Monaco;
- 600 parts sociales à la société S.C.P. TIKI, immatriculée auprès du Registre de Commerce de Monaco, sous le numéro
14 SC16543 et ayant son siège social au 19, Boulevard de Suisse, MC-98000 Monaco;
- 791 parts sociales à la société S.C.P. GLG INVESTMENTS, immatriculée auprès du Registre de Commerce de Monaco,
sous le numéro 14 SC16542 et ayant son siège social au 17, Boulevard Princesse Charlotte, MC-98000 Monaco;
- 629 parts sociales à la société S.C.P. NABILA HK, immatriculée auprès du Registre de Commerce de Monaco, sous
le numéro 14 SC16567 et ayant son siège social au 5bis, Avenue Princesse Alice, MC-98000 Monaco;
- 600 parts sociales à la société Silver BF Ventures Sdn. Bhd, immatriculée auprès du Registre de Commerce de Malaisie,
sous le numéro 838657-M et ayant son siège social au 16
th
Floor, Menara MIDF, 82 Jalan Raja Chulan, 50200 Kuala
Lumpur en Malaisie;
- 908 parts sociales à la société 3C Investments Limited, immatriculée auprès du Registre de Commerce de Hong
Kong, sous le numéro 1813738 et ayant son siège social au Unit 2301, Fook Lee Commercial Centre, Town Place, 33
Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong.
La société GLOBALINK VENTURE LIMITED détient désormais 2.860 parts sociales de la société Energreen Investment
S.à.r.l.
128089
L
U X E M B O U R G
Pour extrait conforme
Le 28 juillet 2014.
Référence de publication: 2014117187/58.
(140135543) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2014.
Ozero Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9647 Doncols, 24, Bohey.
R.C.S. Luxembourg B 107.964.
L'an deux mille quatorze, le dix juillet
Par devant Maître Joëlle SCHWACHTGEN, notaire de résidence à Wiltz.
A comparu:
Monsieur Marc DELOBE, né le 12 octobre 1954 à Evère (B), demeurant à B-1370 Jauchelette, 15, Rue Saint-Pierre
Lequel comparant, présent ou tel que représenté a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
1) Qu’il est l'actionnaire unique de la société anonyme “OZERO GROUP S.A.”, ayant son siège à L-9647 Doncols, 24,
Bohey, constituée suivant acte reçu par le Notaire Léonie GRETHEN, notaire alors de résidence à Rambrouch en date
du 27 juillet 1999, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 775 du 19 octobre 1999,
dont les statuts n’ont pas été modifiés à ce jour
2) Que la société est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, Section B sous le numéro
107.964.
Le capital social de la Société est de trente et un mille euros (31.000.-EUR) entièrement libéré, divisé en trois cent dix
(310) actions sans désignation de valeur nominale.
3) Qu’en tant qu’actionnaire unique il décide de procéder à la dissolution et la liquidation de la société anonyme
OZERO GROUP S.A. avec effet immédiat;
Que la société ne possède pas d’immeuble ni de parts d’immeubles
4) Qu’il décide d’acter la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes et leurs donne décharge pour
la gestion jusqu’à ce jour.
5) Qu’il déclare avoir pleine connaissance des statuts et connaître parfaitement la situation financière de la société
anonyme OZERO GROUP S.A.
Qu’il approuve les comptes arrêtés au 10 juillet 2014. Le bilan de ladite société restera, après avoir été signé «NE
VARIETUR» par les comparants et le notaire instrumentant, annexé au présent acte avec lequel il sera formalisé.
Que la société anonyme OZERO GROUP S-A- est dissoute par l'effet de sa volonté, qu’elle cessera d’exister avec
effet ce jour, qu'exerçant les droits attachés à la propriété de toutes les actions, il est investi de tout l'avoir actif et passif
de la société dont il accepte expressément de recueillir les biens et de prendre en charge les dettes en nom personnel
de manière illimitée et que la liquidation de la société anonyme OZERO GROUP S.A. se trouve ainsi immédiatement et
définitivement clôturée.
6) Qu’il décide que les documents sociaux resteront déposés pendant cinq ans à l'adresse suivante: B-1370 Jauchelette,
15, Rue Saint-Pierre.
7) Qu’il procède à l'annulation des titres.
Pour le dépôt et la publication à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d’une expédition des présentes.
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, est évalué approximativement à neuf cents euros (900,-
EUR).
DONT ACTE, fait et passé en l'étude à Wiltz, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé le présent acte
avec le notaire.
Signé: Delobe M., Joëlle Schwachtgen.
Enregistré à Wiltz, le 11 juillet 2014. Relation: WIL/2014/524. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Pletschette.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société pour servir à des fins administratives.
Wiltz, le 29 juillet 2014.
Référence de publication: 2014115432/50.
(140135000) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2014.
128090
L
U X E M B O U R G
Fa Capital S.A., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande -Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 188.996.
STATUTES
In the year two thousand and fourteen, on the twentieth of June.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
PICIGIEMME S.à r.l., having its registered office at 38, Haerebierg, L-6868 Wecker recorded with the Luxembourg
Trade and Companies' Register, under the number B 75.133,
here represented by Mrs Sonja BEMTGEN, licenciée en criminologie, residing professionally in Luxembourg, by virtue
of a proxy under private seal.
The said proxy, signed “ne varietur” by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the notary to enact as follows the articles of
association of a public limited liability company (société anonyme):
Chapter I. - Name, Registered office, Object, Duration
Art. 1. Form, Name. There is hereby established among the appearing sole shareholder and all those who may become
shareholders a company in the form of a société anonyme, under the name of “FA Capital S.A.” (the “Company”), which
will be governed by the law dated August 10
th
, 1915 on commercial companies, as amended (hereafter the “Law”) as
well as by the present articles of association (hereafter the “Articles”).
Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg City. The registered office of the Company
may be transferred within the City of Luxembourg by a decision of the board of directors.
2.2. The Registered Office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a reso-
lution of the General Meeting of Shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles
2.3. The Company may also, by decision of the Board of Directors, set up subsidiaries, agencies or branch offices either
within or outside the Grand-Duchy of Luxembourg.
2.4. If the board of directors considers that political, economic or social events occurred or threaten to occur which
are likely to affect the normal activities at the registered office or communications from the registered office with abroad,
the registered office may be provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned
to normal. Such measures will not affect the Company's nationality which will notwithstanding such temporary transfer
of the registered office remain a Luxembourg company.
Art. 3. Object. The Company's purpose is to take participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or
foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase
or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licenses, to manage and develop them; to
grant to enterprises in which the Company has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, to perform any
operation which is directly or indirectly related to its purpose.
The Company may borrow under any form whatsoever, through the issue of public or private loans or bonds, whether
interest bearing or profit sharing.
The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly to faci-
litating the accomplishment of its purpose in all areas as described above.
Art. 4. Duration. The Company is established for an unlimited duration. It may be dissolved at any moment by a decision
of the Meeting of Shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
Chapter II. - Capital
Art. 5. Capital - Shares.
5.1. The subscribed corporate capital is set at EUR 100,000 (one hundred thousand euro), divided into 100,000 (one
hundred thousand) shares with a par value of EUR 1 (one euro) each.
5.2. The authorized capital is set at EUR 1,500,000 (one million five hundred thousand euro) divided into 1,500,000
(one million five hundred thousand) shares with a par value of EUR 1 (one euro) each.
5.3. The authorized and the subscribed capital of the Company may be increased or reduced by resolutions of the
shareholders adopted in the manner required for amending these Articles of Incorporation.
5.4. Furthermore the Board of Directors is authorized, during a period of five (5) years ending on June 20
th
, 2019,
to increase from time to time the subscribed capital, within the limits of the authorized capital. This increase of capital
128091
L
U X E M B O U R G
may be subscribed and shares issued with or without issue premium and paid up by contribution in kind or cash, by
incorporation of claims in any other way to be determined by the Board of Directors. The Board of Directors is specifically
authorized to proceed to such issues without reserving for the then existing shareholders a preferential right to subscribe
to the shares to be issued. The Board of Directors may delegate to any duly authorized Director or officer of the Company,
or to any other duly authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares repre-
senting part or all of such increased amounts of capital.
5.5. Each time the Board of Directors shall act to render effective an increase of the subscribed capital, the present
article shall be considered as automatically amended in order to reflect the result of such action.
5.6. The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the limits set by law.
5.7. Any share premium may be distributed by the shareholders' meeting in the form of distribution of free reserves
of the company.
Art. 6. Payments. Payments on shares not fully paid up at the time of subscription will be made at the time and upon
conditions, which the Board of Directors shall from time to time determine. Any amount called up on shares will be
charged equally on all outstanding shares, which are not fully paid.
Art. 7. Shares.
7.1. The shares are in registered or bearer form, at request of the shareholder.
7.2. A register of registered shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any
shareholder.
7.3. Ownership of registered shares will be established by inscription in the said register.
Art. 8. Transfer of shares.
8.1. There exist no restrictions about transactions or transfer of shares of the Corporation.
8.2. The Company will recognize only one holder per share. In case a share is held by more than one person, the
Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed
as sole owner in relation to the Company. The same rule shall apply in the case of conflict between an usufructuary
(usufruitier) and a bare owner (nu-propriétaire) and a pledgor and a pledgee.
Art. 9. Convertible bonds.
9.1. The Board may, upon previous authorization by the shareholders' meeting, issue convertible bonds under the
form of nominative certificates or bearer certificates, payable in any currency.
9.2. The Board will determine the nature, issue price, interest rate, terms and conditions for issue and repurchase, as
well as all other conditions of the issue. In case of nominative certificates, a register will be held at the registered office.
Chapter III. - Directors, Board of directors, statutory auditors
Art. 10. Meetings of shareholders - General.
10.1. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders' meeting.
10.2. In case of plurality of shareholders, any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall
represent the entire body of shareholders of the Company.
The general meeting of shareholders shall have the widest powers to adopt or ratify any action relating to the Company.
In particular, the general meeting of shareholders shall have competence in all matters where the board of directors, in
its sole discretion, requests the formal approval of the general meeting of shareholders.
10.3. Any general meeting of shareholders shall be convened as set forth in the Law.
10.4. Each Share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another
person as his proxy in writing or by fax or telegram or telex or electronic mail.
10.5. Except as otherwise required by Law, resolutions at an annual or ordinary meeting of shareholders duly convened
will be passed by a simple majority of shareholders present and voting, regardless of the proportion of the capital repre-
sented.
An extraordinary general meeting convened to amend any provisions of the Articles shall not validly deliberate unless
at least one half of the share capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles.
If the first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the Law.
Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the previous meeting. The
second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the share capital represented. At both meetings,
resolutions, in order to be adopted, must be approved by a two thirds majority of the shareholders present or repre-
sented.
However, the nationality of the Company may be changed and the shareholder commitments may be increased only
with the unanimous consent of all the shareholders.
10.6. The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders in order to take
part in any meeting of shareholders.
128092
L
U X E M B O U R G
10.7. If all the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have
been informed of the agenda of the meeting, the shareholders may validly waive any convening formalities.
Art. 11. Board of directors.
11.1. The Company shall be managed by a board of directors composed of at least three (3) directors, who need not
to be shareholders of the Company.
11.2. However, if the Company is set up by a single shareholder or if, at a general shareholders meeting, it is acknow-
ledged that the meeting includes no more than one sole shareholder, the composition of the board of directors may be
limited to one member up to and until the next shareholders meeting evidencing that there is more than only one
shareholder.
11.3. The directors shall be appointed at the general shareholders' meeting for a period of maximum six years and
shall stay in office until their successors are elected. They are re-eligible. They may be removed at any time by a resolution
of the general meeting of shareholders. They will remain in function until their successors have been appointed. In case
a director is elected without mention of the term of his mandate, he is deemed to be elected for six (6) years from the
date of his election.
11.4. If a body corporate is appointed as director of the Company, it shall nominate a permanent representative
responsible for the carrying out of its mission in the name of and on behalf of the body corporate.
11.5. A director may be removed with or without cause and replaced at any time by resolution adopted in a general
shareholders meeting.
11.6. In the event of one or more vacancies on the board of directors because of death, retirement or otherwise, the
remaining directors may appoint within thirty business days one or more successors to fill such vacancies which shall
remain in office until the next general meeting of shareholders or convene a general shareholders meeting for their
immediate replacement.
11.7. The directors shall not be compensated for their services as director, unless otherwise resolved by the general
meeting of shareholders. The Company shall reimburse the directors for reasonable expenses incurred in the carrying
out of their office, including reasonable travel and living expenses incurred for attending meetings on the board of direc-
tors.
Art. 12. Indemnification. The Company may indemnify any director or officer and his heirs, executors and adminis-
trators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may
be made a party by reason of his being or having been a director or officer of the Company or, at his request, of any
other corporation of which the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified,
except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for
gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with
such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified
did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he
may be entitled.
Art. 13. Procedural aspects.
13.1. In case of plurality of directors, the board of directors may choose from among its members a chairman and a
vice-chairman. Whatever the composition of the board of directors is, the Chairman may also choose a secretary, who
need not be a director and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors
and of the shareholders.
13.2. The board of directors shall meet upon call by the chairman or two directors at the place indicated in the
convening notice. The convening notice, containing the agenda, shall be sent by letter (sent by express mail or special
courier), telegram, fax, electronic mail to each director at least 3 (three) Business Days before the date set for the meeting,
except in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the convening
notice and in which case notice of at least 24 hours prior to the hour set for such meeting by telegram, fax, electronic
mail shall be sufficient. This notice may be waived by the consent in writing or by fax, telegram or electronic mail. No
notice shall be required for board of directors' meetings held at those times and places as previously agreed upon by the
board of directors.
13.3. Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing by fax, telegram or
electronic mail another director as his proxy. The use of video and teleconferencing equipment shall be allowed and the
directors using this technology shall be deemed to be physically present and authorised to vote.
13.4. In case of plurality of directors, the board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of
directors are present at the meeting of the board of directors.
13.5. Decisions shall be taken by a majority of the votes cast of those present or represented at such meeting.
13.6. Written resolutions signed by the sole director or, in case of plurality of directors, by all the members of the
board of directors shall have the same effect as resolutions validly adopted during a meeting of the board of directors.
13.7. For the purposes of these Articles, “Business Day” means any calendar day (other than a Saturday or a Sunday)
on which banks are open for business in Luxembourg.
128093
L
U X E M B O U R G
Art. 14. Minutes of meetings of the board.
14.1. The resolutions of the board of directors shall be recorded in minutes to be signed by two Directors present at
the meeting.
14.2. The resolutions adopted by the sole director shall be recorded in the minutes of the Company.
14.3. Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed
by the sole director or, in case of plurality of directors, by any one of the directors under his sole signature.
Art. 15. Powers of the board.
15.1. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition.
All powers not expressly reserved by Law or by the Articles to the general meeting of shareholders fall within the
competence of the board of directors.
15.2. The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company
and the representation powers in respect thereof, to one of the members of the board of directors who shall be designated
as the managing director. The board of directors may also confer special powers and special mandates to any person who
need not to be a director, appoint and dismiss all officers and employees and determine their remuneration.
15.3. Such delegation in favor of a member of the board of directors shall entail the obligation for the board of directors
to report each year to the general meeting on the salary, fees and any advantages granted to managing director.
Art. 16. Binding signature. The Company will be bound by the sole signature of the sole director or, in case of plurality
of directors, by the joint signatures of any two directors of the Company or by the joint or single signatures of any person
to whom any signatory powers shall have been delegated by the board of directors.
Art. 17. Statutory auditor. The operations of the Company shall be supervised by one or more statutory auditors as
foreseen by Law who need not to be shareholder of the Company. If there is more than one statutory auditor, the
statutory auditors shall form the board of auditors. The statutory auditors shall be appointed by the annual general meeting
of shareholders for a period ending of up to six (6) years.
Art. 18. Appropriation of profits.
18.1. Legal Reserve.
From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the statutory reserve account.
This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the
subscribed capital of the Company.
18.2. Dividends.
The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, shall determine how the re-
mainder of the annual net profits shall be disposed of and may declare from time to time ordinary dividends without ever
exceeding the amounts proposed by the board of directors.
Interim dividends may be distributed, subject to the conditions laid down by Law.
Art. 19. Dissolution and liquidation.
19.1. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in
the manner required for amendment of these Articles.
19.2. In the event of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators
appointed by the meeting of shareholders further determining their powers and their compensation.
Art. 20. Governing law. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the Law.
Art. 21. Annual general meeting of shareholders.
21.1. The annual general meeting of shareholders shall be held at the registered office of the Company, or at such
other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the first Friday of the month of October at 2
p.m.
21.2. If such day is not a Business Day, the annual general meeting shall be held on the next following Business Day.
The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the board of directors, exceptional
circumstances so require.
21.3. Other meetings of shareholders, ordinary and extraordinary, may be held at such places and times as may be
specified in the respective convening notices.
Art. 22. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on July 1
st
and shall terminate on June 30
th
of each year.
<i>Transitional dispositionsi>
1) The first accounting year shall begin on the date of incorporation of the Company and shall terminate on June 30
th
, 2015.
2) The first annual general meeting of shareholders shall take place in 2015.
128094
L
U X E M B O U R G
<i>Subscriptioni>
The Articles having thus been established, the share capital has been subscribed as follows:
Subscriber
Number
of Shares
Subscribed
amount
(in EUR)
% of share
capital
PICIGIEMME S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,000 100,000.00
100.00 %
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,000 100,000.00
100.00 %
All the Shares have been fully paid up by payment in cash together with a freely distributable share premium of an
aggregate amount of EUR 301,095.44 (three hundred one thousand ninety-five euro and forty-four cents), so that the
aggregate amount of EUR 401,095.44 (four hundred one thousand ninety-five euro and forty-four cents) is now available
to the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary by the production of a blocking certificate.
<i>Statementi>
The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10
th
,
1915 on commercial companies, as amended have been duly observed.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
Company incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately EUR 2,100 (two thousand one
hundred euro).
<i>Extraordinary general meetingi>
The above appearing party, representing the entire subscribed share capital has immediately adopted the following
resolutions:
1. The number of Directors is fixed at THREE (3).
2. The following are appointed Directors:
- Mrs. Sonja BEMTGEN, licenciée en criminologie, professionally residing at 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
L-1331 Luxembourg, chairman;
- Mrs. Sarah LOBO, Master of Commerce, professionally residing at 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331
Luxembourg; and
- Mrs. Virginie DERAINS, employee, professionally residing at 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331
Luxembourg.
Unless renewed, their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2019.
3. Has been appointed statutory auditor:
PICIGIEMME S.à r.l., having its registered office at 38, Haerebierg, L-6868 Wecker recorded with the Luxembourg
Trade and Companies' Register, under the number B 75.133.
Unless renewed, the term of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2019.
4. The registered office of the Company is established at 31, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxem-
bourg.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the mandatory of the appearing party, acting as said before, known to the notary
by name, first name, civil status and residence, the said mandatory has signed with Us the notary the present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille quatorze, le vingt juin.
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.
A COMPARU:
PICIGIEMME S.à r.l., ayant son siège social au 38, Haerebierg, L-6868 Wecker, enregistré auprès du Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 75.133,
ici représentée par Madame Sonja BEMTGEN, licenciée en criminologie, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée “ne varietur” par le mandataire du comparant et le notaire ins-
trumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
128095
L
U X E M B O U R G
Lequel comparant, ès-qualités qu'il agit, a requis du notaire instrumentant qu'il dresse l'acte constitutif d'une société
anonyme qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
. - Dénomination, Siège, Objet, Durée
Art. 1
er
. Forme, Dénomination. Il est formé, entre l'unique actionnaire comparant et tous ceux qui deviendront dans
la suite actionnaires d'une société constituée sous la forme d'une société anonyme sous la dénomination de «FA Capital
S.A.» (la «Société»), laquelle sera régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après la «Loi») ainsi que par les présents statuts (ci-après les «Statuts»).
Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville. Le siège social de la Société pourra être transféré à
l'intérieur de la Ville de Luxembourg par une décision du conseil d'administration.
2.2. Le siège social pourra être transféré à tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg sur décision de l'As-
semblée générale délibérant dans les formes prévues par les modifications de statuts.
2.3. La société peut également par décision du conseil d'administration, créer, tant dans le Grand-Duché de Luxem-
bourg qu'à l'étranger, des filiales, agences ou succursales.
2.4. Lorsque le conseil d'administration détermine que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique
ou social se sont produits ou sont imminents, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la commu-
nication de ce siège avec l'étranger, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'au moment où
les circonstances seront redevenues complètement normales; de telles mesures temporaires ne changent en rien la
nationalité de la Société, qui restera luxembourgeoise malgré le transfert temporaire de son siège statutaire.
Art. 3. Objet. La société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises
commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits
par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre
manière et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux entreprises
auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations géné-
ralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.
La société peut emprunter sous toutes les formes, soit par l'émission d'emprunts ou de financements publics ou privés,
avec intérêts ou par participation aux profits
La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte
avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l'accomplissement.
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute à tout moment par décision
des actionnaires délibérant aux conditions requises pour une modification statutaire.
Titre II. - Capital
Art. 5. Capital - Actions.
5.1. Le capital social souscrit est fixé à EUR 100.000 (cent mille euros), divisé en 100.000 (cent mille) actions d'une
valeur nominale de EUR 1 (un euro) chacune.
5.2. Le capital autorisé est fixé à EUR 1.500.000 (un million cinq cent mille euros) qui sera divisé en 1.500.000 (un
million cinq cent mille) actions de EUR 1 (un euro) chacune.
5.3. Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décisions de l'assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
5.4. En outre le conseil d'administration est, pendant une période de cinq (5) ans se terminant le 20 juin 2019, autorisé
à augmenter en temps utile qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmen-
tations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission et libérées par
apport en nature ou en numéraire, par compensation avec des créances ou de toute autre manière à déterminer par le
conseil d'administration. Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans
réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d'adminis-
tration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée pour
recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation
de capital.
5.5. Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital
souscrit, le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.
5.6. La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
5.7. Toute prime d'émission peut être distribuée par l'assemblée générale dans les conditions d'une réserve libre de
la société.
128096
L
U X E M B O U R G
Art. 6. Versements. Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription se
feront aux époques et aux conditions que le conseil d'administration déterminera dans ces cas. Tout versement appelé
s'impute à parts égales sur l'ensemble des actions qui ne sont pas entièrement libérées.
Art. 7. Nature des actions.
7.1. Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.
7.2. Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire pourra prendre connaissance.
7.3. La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur ledit registre.
Art. 8. Cession d'actions.
8.1. Il n'existe aucune restriction statutaire quant aux transactions ou aux cessions d'actions de la société.
8.2. La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Dans le cas où une action viendrait à appartenir à plusieurs
personnes, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne
ait été désignée comme étant propriétaire unique à son égard. Il en sera de même dans le cas d'un conflit opposant
l'usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier gagiste.
Art. 9. Emprunts obligataires convertibles.
9.1. Le conseil d'administration peut, sur décision de l'assemblée générale des actionnaires, autoriser l'émission d'em-
prunts obligataires convertibles sous forme d'obligations nominatives ou au porteur, payables en quelque monnaie que
ce soit.
9.2. Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêts, les conditions d'émission et de rem-
boursement et toutes autres conditions y ayant trait. Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de
la société.
Titre III. - Administration, Direction, Surveillance
Art. 10. Assemblées des actionnaires - Général.
10.1. L'actionnaire unique exerce tous pouvoirs conférés à l'assemblée générale des actionnaires.
10.2. En cas de pluralité d'actionnaires, chaque assemblée des actionnaires de la Société, régulièrement constituée,
représente l'intégralité des actionnaires de la Société.
L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la
Société. En particulier, l'assemblée générale des actionnaires sera compétente dans tous les domaines dans lesquels le
conseil d'administration, à sa seule discrétion, requiert une approbation formelle de l'assemblée générale des actionnaires.
10.3. Toute assemblée générale des actionnaires sera convoquée conformément à la Loi.
10.4. Chaque Action ordinaire donne droit à une voix. Un actionnaire peut agir à toute assemblée des actionnaires en
désignant une autre personne comme mandataire, par écrit, par fax, par télégramme, par télex ou courrier électronique.
10.5. Sauf stipulations contraires de la Loi, les décisions prises par l'assemblée générale annuelle ou ordinaire des
actionnaires, dûment convoquée seront prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants, indépendamment
de la proportion du capital représenté.
Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier les Statuts dans toutes ses
dispositions ne pourra valablement délibérer que si la moitié au moins du capital est représentée et que l'ordre du jour
indique les modifications statutaires proposées. Si la première de ces conditions n'est pas remplie une nouvelle assemblée
des actionnaires peut être convoquée, dans les formes prévues par la Loi. Cette convocation reproduit l'ordre du jour,
en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée des actionnaires délibère valablement
quelle que soit la portion du capital représentée. Dans les deux assemblées des actionnaires, les résolutions pour être
approuvées devront réunir une majorité de deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.
Néanmoins, le changement de nationalité de la Société et l'augmentation des engagements des actionnaires ne peuvent
être décidés qu'avec l'accord unanime des actionnaires.
10.6. Le conseil d'administration pourra déterminer toutes les autres conditions qui devront être remplies par les
actionnaires afin de participer à toute assemblée des actionnaires.
10.7. Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent qu'ils ont
été informés de l'ordre du jour de l'assemblée, les actionnaires pourront valablement dispenser de toutes formalités de
convocations.
Art. 11. Conseil d'administration.
11.1. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé d'au moins trois (3) administrateurs, qui
n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société.
11.2. Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou qu'à une assemblée générale des ac-
tionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut
être limitée à un administrateur unique jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de
plus d'un actionnaire.
128097
L
U X E M B O U R G
11.3. Les administrateurs seront désignés lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période de
six ans maximum et resteront en fonction jusqu'à l'élection de leurs successeurs. Ils sont rééligibles. Ils peuvent être
révoqués à tout moment par l'assemblée générale des actionnaires. Ils restent en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs
soient nommés. Les administrateurs élus sans indication de la durée de leur mandat, seront réputés avoir été élus pour
un terme de six (6) ans.
11.4. Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant per-
manent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de cette personne morale.
11.5. Un administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif et remplacé à tout moment sur décision adoptée lors
de l'assemblée générale des actionnaires.
11.6. En cas de vacance d'un ou plusieurs postes d'administrateur, pour cause de décès, retraite ou autre, les admi-
nistrateurs restants pourront désigner dans les trente jours ouvrables suivants, un ou plusieurs successeurs pour palier
ces postes vacants, lequel restera en fonction jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires; ou convoquer
une assemblée générale des actionnaires pour son remplacement immédiat.
11.7. Les membres du conseil d'administration ne seront pas rémunérés pour leurs services en tant qu'administrateur,
sauf s'il en est décidé autrement par l'assemblée générale des actionnaires. La Société pourra rembourser aux adminis-
trateurs les dépenses raisonnables survenues lors de l'exécution de leur mandat, y compris les dépenses raisonnables de
voyage et de logement survenus lors de la participation à des réunions du conseil d'administration.
Art. 12. Indemnisation. La Société peut indemniser tout administrateur ou directeur et ses héritiers, exécuteurs et
administrateurs testamentaires pour des dépenses raisonnablement encourues par lui en rapport avec toute action, pro-
cès ou procédure à laquelle il sera impliqué en raison du fait qu'il a été ou qu'il est un administrateur ou directeur de la
Société ou, à la requête de toute autre société de laquelle la Société est actionnaire ou créancière et de laquelle il n'est
pas en droit d'être indemnisé, excepté en relation avec des affaires dans lesquelles il sera finalement jugé responsable de
négligence grave ou de mauvaise gestion; en cas d'arrangement, l'indemnisation sera seulement réglée en relation avec
les affaires couvertes par l'arrangement et pour lesquelles la Société obtient l'avis d'un conseiller que la personne qui doit
être indemnisée n'a pas failli à ses devoirs de la manière visée ci-dessus. Le précédent droit d'indemnisation n'exclut pas
d'autres droits auxquels il a droit.
Art. 13. Modalités procédurales.
13.1. En cas de pluralité d'administrateurs, le conseil d'administration pourra choisir parmi ses membres, un président
et un vice-président. Quelle que soit la composition du conseil d'administration, son Président pourra aussi choisir un
secrétaire qui n'a pas besoin d'être un administrateur et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions
du conseil d'administration et des assemblées générales.
13.2. Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs au lieu indiqué
dans la convocation. La convocation contenant l'agenda doit être envoyée par lettre (courrier express ou courrier spécial),
par fax, par télégramme, fax courrier électronique à chaque administrateur au moins 3 (trois) Jours Ouvrables avant la
date prévue de la réunion, sauf dans des circonstances d'urgence, dont la nature devra figurer dans la convocation, il
suffira que la convocation soit envoyée au moins 24 heures avant l'heure fixée pour la réunion, par télégramme, fax ou
courrier électronique. Cette convocation peut être levée par le consentement donné par écrit, par fax, télégramme ou
courrier électronique. Une convocation ne sera pas requise pour les réunions du conseil d'administration tenues à des
dates, heures et places précédemment convenues par le conseil d'administration.
13.3. Chaque administrateur peut agir à toute réunion du conseil d'administration en nommant un autre Administra-
teur, par écrit, par fax, par télégramme ou par courrier électronique, comme son mandataire. L'utilisation d'équipement
vidéo et de téléconférence est autorisée et les administrateurs utilisant ces technologies sont présumés être physiquement
présents et autorisés à voter.
13.4. En cas de pluralité d'administrateurs, le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si
la majorité des administrateurs est présente à la réunion du conseil d'administration.
13.5. Les décisions seront prises à la majorité des voix exprimées des administrateurs présents ou représentés à cette
réunion.
13.6. Les résolutions écrites signées par l'administrateur unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par tous les
membres du conseil d'administration auront le même effet que celles valablement prises lors d'une réunion du conseil
d'administration.
13.7. Dans la perspective des Statuts, «Jours Ouvrables» a pour signification tout jour calendrier (autre que samedi et
dimanche) pendant lequel les banques sont ouvertes pour affaires à Luxembourg.
Art. 14. Procès-verbaux des conseils d'administration.
14.1. Les résolutions du conseil d'administration seront constatées par des procès-verbaux signés par deux adminis-
trateurs présents à la réunion.
14.2. Les résolutions prises par l'administrateur unique seront constatées par des procès-verbaux.
14.3. Les copies et extraits de ces procès-verbaux qui pourraient être produits en justice ou autrement seront signés
par son administrateur unique ou en cas de pluralité d'administrateurs, par un des administrateurs sous sa seule signature.
128098
L
U X E M B O U R G
Art. 15. Pouvoirs du conseil d'administration.
15.1. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour effectuer tous les actes d'administration
ou de disposition. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts à l'assemblée
générale, tombent sous la compétence du conseil d'administration.
15.2. Le conseil d'administration pourra déléguer ses pouvoirs de gestion journalière et les affaires courantes de la
Société ainsi que les pouvoirs de représentation de la Société en relation avec ceux - ci à un des membres du conseil
d'administration, qui sera nommé comme administrateur - délégué. Le conseil d'administration pourra en outre conférer
des pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes, qui n'ont pas besoin d'être administrateur, afin de nommer et
révoquer tous agents et employés et de fixer leurs rémunérations.
15.3. Une telle délégation à un membre du conseil d'administration impose à celui-ci l'obligation de rendre annuellement
compte à l'assemblée générale des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués à cet administrateur-dé-
légué.
Art. 16. Pouvoirs de représentation. La Société est engagée par la seule signature de l'administrateur unique ou, en
cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux des administrateurs de la Société ou par la signature
conjointe ou unique de toute personne à laquelle des pouvoirs de signature a été délégué par le conseil d'administration.
Art. 17. Commissaires aux comptes. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs commissaires
aux comptes, tel que prévu par la Loi et qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société. S'il y a plus d'un commissaire
aux comptes, les commissaires aux comptes formeront le conseil des commissaires aux comptes. Les commissaires aux
comptes sont nommés par l'assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période de maximum six (6) ans.
Art. 18. Affectation des bénéfices.
18.1. Réserve Légale.
Du bénéfice net annuel de la Société, cinq pour cent (5%) seront alloués au compte de la réserve statutaire. Ces
allocations cesseront d'être obligatoires dès que, et aussi longtemps que, cette réserve atteindra dix pour cent (10%) du
capital social souscrit de la Société.
18.2. Dividendes.
L'assemblée générale des actionnaires, sur recommandation du conseil d'administration, déterminera de quelle façon
il sera disposé du solde du bénéfice annuel net et pourra déclarer de temps à autre des dividendes ordinaires sans jamais
excéder les montants proposés par le conseil d'administration.
Des dividendes intermédiaires pourront être distribués, sous réserve des conditions prévues par la Loi.
Art. 19. Dissolution et liquidation.
19.1. La Société pourra être dissoute à tout moment en vertu d'une décision de l'assemblée générale des actionnaires
prise dans les formes requises pour les modifications des Statuts.
19.2. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs nommés par
l'assemblée générale des actionnaires, déterminant en outre leurs pouvoirs et rémunérations.
Art. 20. Loi applicable. Pour tous les points non réglés aux présents Statuts, les parties se réfèrent et se soumettent
à la Loi.
Art. 21. Assemblée générale annuelle.
21.1. L'assemblée générale annuelle des actionnaires sera tenue au siège social de la Société, ou à tout autre endroit
à Luxembourg stipulé dans la convocation, le premier vendredi du mois d'octobre à 14:00 heures.
21.2. Si ce jour n'est pas un Jour Ouvrable, l'assemblée générale annuelle sera tenue le Jour Ouvrable suivant. L'as-
semblée générale pourra être tenue à l'étranger, si de l'opinion absolue et finale du conseil d'administration, des
circonstances exceptionnelles le requièrent.
21.3. D'autres assemblées des actionnaires, ordinaires ou extraordinaires, pourront être tenues en lieux et places tels
que spécifié dans les avis de convocations.
Art. 22. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le 1
er
juillet et se termine le 30 juin de l'année
suivante.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commencera à la date de constitution de la Société et prendra fin le 30 juin 2015.
2) La première assemblée générale des actionnaires se tiendra en 2015.
<i>Souscriptioni>
Les Statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, le capital social a été souscrit comme suit:
128099
L
U X E M B O U R G
Souscripteur
Nombre
d'Actions
Montant
souscrit
(en EUR)
% du capital
social
PICIGIEMME S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.000
100.000
100,00 %
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.000
100.000
100,00 %
Les Actions ont été intégralement libérées par paiement en espèces ensemble avec une prime d'émission d'un montant
de EUR 301.095,44 (trois cent un mille quatre-vingt-quinze euros et quarante-quatre centimes), de sorte que la somme
total de EUR 401.095,44 (quatre cent un mille quatre-vingt-quinze euros et quarante-quatre centimes) se trouve dès à
présent à la libre disposition de la Société, ainsi que preuve en a été donnée au notaire soussigné par la production d'un
certificat bancaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales, telle que modifiée ont été dûment accomplies.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ EUR 2.100 (deux mille cents
euros).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Le comparant ci-dessus, représentant la totalité du capital souscrit a immédiatement adopté les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à TROIS (3).
2. Sont nommés administrateurs:
- Madame Sonja BEMTGEN, licenciée en criminologie, avec adresse professionnelle au 31, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1331 Luxembourg, Président;
- Madame Sarah LOBO, Master of Commerce, avec adresse professionnelle au 31, boulevard Grande-Duchesse Char-
lotte, L-1331 Luxembourg; et
- Madame Virginie DERAINS, employée privée, avec adresse professionnelle au 31, boulevard Grande-Duchesse Char-
lotte, L-1331 Luxembourg.
Sauf renouvellement, leur mandat viendra à expiration lors de la tenue de l'assemblée générale annuelle de 2019.
3. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
PICIGIEMME S.à r.l., ayant son siège social au 38, Haerebierg, L-Wecker, enregistré auprès Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 75.133.
Sauf renouvellement, son mandat viendra à expiration lors de la tenue de l'assemblée générale annuelle de 2019.
4. Le siège social de la Société est fixé au 31, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l'a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte au mandataire de la comparante, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par nom,
prénom, état civil et domicile, ledit mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: S. Bemtgen et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 juin 2014. LAC/2014/28926. Reçu soixante-quinze euros (75.- €)
<i>Le Receveuri> (signé): Irène Thill.
POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juillet 2014.
Référence de publication: 2014117242/538.
(140135630) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2014.
Euroland Properties S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 278, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 121.422.
L’an deux mille quatorze, le dix juillet,
Par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg,
128100
L
U X E M B O U R G
S’est réunie
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme, «EUROLAND PROPERTIES S.A.», ayant
son siège social à L-8070 Bertrange, 10B, rue des Merovingiens, constituée suivant acte notarié, en date du 10 novembre
2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 2392 du 22 décembre 2006, immatriculée
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 121.422 (la «Société»).
Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié en date du 26 juin 2008, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1854 du 28 juillet 2008.
L’assemblée est ouverte à 15.00 heures sous la présidence de Madame Cheryl GESCHWIND, employée privée, rési-
dant professionnellement à L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains,
qui désigne comme secrétaire Madame Anita MAGGIPINTO, employée privée, résidant professionnellement à L-1212
Luxembourg, 17, rue des Bains.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Pierre BERCKMANS, employé privé, résidant professionnelle-
ment à L-1463 Luxembourg, 29, rue du Fort Elisabeth.
Le bureau ainsi constitué, le président a exposé et prié le notaire instrumentant d’acter:
I. Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Transfert du siège social de L-8070 Bertrange, 10B, rue des Merovingiens vers 278, route d’Esch à L-1471 Luxem-
bourg.
2. Modification subséquente du point I, article 4 des statuts.
3. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes, les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-
phées ne varietur par les comparants.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:
<i>Résolution unique:i>
L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la Société de L-8070 Bertrange, 10B, rue des Merovingiens
vers L-1471 Luxembourg, 278, route d’Esch.
Par conséquent, l’assemblée générale décide de modifier la première phrase du premier paragraphe de l’article 4 des
statuts, pour lui donner désormais la teneur suivante:
« Art. 4. (premier paragraphe - première phrase). Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg.»
Plus rien n'étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: C. GESCHWIND, A. MAGGIPINTO, J.P. BERCKMANS et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 15 juillet 2014. LAC / 2014 / 33104. Reçu soixante quinze euros- 75,-
<i>Le Receveuri> (signé): THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.
Luxembourg, le 28 juillet 2014.
Référence de publication: 2014117221/57.
(140135741) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2014.
128101
L
U X E M B O U R G
Dimple Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 184.054.
In the year two thousand and fourteen, on the twenty-third day of the month of July,
Before Maître Francis Kesseler, notary, residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held
an extraordinary general meeting of the shareholders (the "Meeting") of DIMPLE HOLDING S.A., a public limited
liability company (“Société Anonyme”) incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 8-10,
avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated by a deed enacted by the undersigned
notary on 29 November 2013, published in the “Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations” number 804 dated
28 March 2014, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 184.054 (the
"Company").
The Meeting is presided by Hervé Hautin, private employee, professionally residing in 8, avenue de la Gare, L-1610
Luxembourg
The chairman appoints as secretary Sébastien Wiander, private employee, professionally residing in 8, avenue de la
Gare, L-1610 Luxembourg.
The Meeting elects as scrutineer Laurent Huss, company director, residing professionally in 43, am Duerf, L-8289
Kehlen.
The bureau having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to act that:
I. The name of the shareholders and the number of shares held by them are shown on an attendance list signed by the
shareholders present, the proxyholders of the shareholders represented and by the members of the Meeting. The list
and the proxies, signed "ne varietur" by the appearing persons, the members of the bureau and the undersigned notary
shall remain annexed to the present deed to be filed therewith with the registration authorities.
II. It appears from the said attendance list that out the 110,140 (one hundred ten thousand one hundred forty) shares
representing the whole share capital of the Company, all shares are present or represented at the Meeting. The Meeting
is therefore validly constituted and may validly resolve on its agenda known to the shareholders present or represented.
III. The shareholders represented declare having had full knowledge of the agenda of the Meeting and waiving their
rights to prior notice so that the Meeting can validly decide on all items of the agenda.
IV. The agenda of the Meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Waiving of notice right;
2. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 860,910 (eight hundred sixty thousand nine
hundred ten Euros) so as to raise it from its current amount of EUR 110,140 (one hundred ten thousand one hundred
forty Euros) to EUR 971,050 (nine hundred seventy-one thousand fifty Euros) by the issuance of 860,910 (eight hundred
sixty thousand nine hundred ten) new shares with a nominal value of EUR 1 (one Euro), to be fully paid-up through
contributions in kind;
3. Subscription and payment of 860,910 (eight hundred sixty thousand nine hundred ten) new shares by the contri-
butors by way of contributions in kind;
4. Subsequent amendment of article 5 of the articles of association of the Company; and
5. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the Meeting, the following resolutions have been taken:
<i>First resolution:i>
It is unanimously resolved that the shareholders waive their right to prior notice of the current Meeting. The share-
holders acknowledge having been sufficiently informed of the agenda for the Meeting and confirm that they consider the
Meeting validly convened and therefore agree to deliberate and vote upon all the items on the agenda. It was further
unanimously resolved that all the relevant documentation has been put at the disposal of the shareholders within sufficient
period of time in order to allow them to carefully examine each document.
<i>Second resolution:i>
It is unanimously resolved to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 860,910 (eight hundred
sixty thousand nine hundred ten Euros) so as to raise it from its current amount of EUR 110,140 (one hundred ten
thousand one hundred forty Euros) to EUR 971,050 (nine hundred seventy-one thousand fifty Euros) by the issuance of
860,910 (eight hundred sixty thousand nine hundred ten) new shares with a nominal value of EUR 1 (one Euro) (the “New
Shares”), to be fully paid up through contributions in kind as described below (the “Contributions”).
128102
L
U X E M B O U R G
<i>Third resolution:i>
It is unanimously resolved to accept the subscriptions and the payments by the contributors of the New Shares through
the Contributions as described below.
<i>Intervention - Subscription - Paymenti>
Thereupon intervene the contributors, here represented by Hervé Hautin and Sébastien Wiander, prenamed, by virtue
of proxies given under private seal who declares to subscribe to the New Shares, as follows:
- Penshire Luxembourg S.à r.l.: 337,471 (three hundred thirty-seven thousand four hundred seventy-one) New Shares;
- Orion S.C.: 203,962 (two hundred three thousand nine hundred sixty-two) New Shares;
- Korafin S.A.S.: 55,452 (fifty-five thousand four hundred fifty-two) New Shares;
- Arnaud Million: 45,891 (forty-five thousand eight hundred ninety-one) New Shares;
- Christophe Neumann: 39,773 (thirty-nine thousand seven hundred seventy-three) New Shares;
- Julien Leleu: 39,773 (thirty-nine thousand seven hundred seventy-three) New Shares;
- Yann Dremière: 22,945 (twenty-two thousand nine hundred forty-five) New Shares;
- Nathalie Couté: 3,824 (three thousand eight hundred twenty-four) New Shares;
- Cécile Coulon: 6,119 (six thousand one hundred nineteen) New Shares;
- Sylvie Rakinski: 7,648 (seven thousand six hundred forty-eight) New Shares;
- Laurence Chaumeil: 5,354 (five thousand three hundred fifty-four) New Shares;
- Claire Pouliquen: 4,589 (four thousand five hundred eighty-nine) New Shares;
- Christian Depoortere: 3,824 (three thousand eight hundred twenty-four) New Shares;
- Paul Vaissié: 2,700 (two thousand seven hundred) New Shares; and
- Florence Fesneau: 81,585 (eighty-one thousand five hundred eighty-five) new Shares.
The New Shares have been fully paid up by the contributors through the Contributions as described below.
<i>Description of the contributioni>
The Contributions made by the contributors are composed as follows:
- a receivable held by Penshire Luxembourg S.à r.l. in an amount of EUR 337,471 (three hundred thirty-seven thousand
four hundred seventy-one Euros);
- a receivable held by Orion S.C. in an amount of EUR 203,962 (two hundred three thousand nine hundred sixty-two
Euros);
- a receivable held by Korafin S.A.S. in an amount of EUR 55,452 (fifty-five thousand four hundred fifty-two Euros);
- a receivable held by Arnaud Million in an amount of EUR 45,891 (forty-five thousand eight hundred ninety-one Euros);
- a receivable held by Christophe Neumann in an amount of EUR 39,773 (thirty-nine thousand seven hundred seventy-
three Euros);
- a receivable held by Julien Leleu in an amount of EUR 39,773 (thirty-nine thousand seven hundred seventy-three
Euros);
- a receivable held by Yann Dremiere in an amount of EUR 22,945 (twenty-two thousand nine hundred forty-five
Euros);
- a receivable held by Nathalie Couté in an amount of EUR 3,824 (three thousand eight hundred twenty-four Euros);
- a receivable held by Cécile Coulon in an amount of EUR 6,119 (six thousand one hundred nineteen Euros);
- a receivable held by Sylvie Rakinski in an amount of EUR 7,648 (seven thousand six hundred forty-eight Euros);
- a receivable held by Laurence Chaumeil in an amount of EUR 5,354 (five thousand three hundred fifty-four Euros);
- a receivable held by Claire Pouliquen in an amount of EUR 4,589 (four thousand five hundred eighty-nine Euros);
- a receivable held by Christian Depoortere in an amount of EUR 3,824 (three thousand eight hundred twenty-four
Euros);
- a receivable held by Paul Vaissié in an amount of EUR 2,700 (two thousand seven hundred Euros);
- a receivable held by Florence Fesneau in an amount of EUR 81,585 (eighty-one thousand five hundred eighty-five
Euros).
The Contributions are evaluated at EUR 860,910 (eight hundred sixty thousand nine hundred ten Euros). The Con-
tributions have been examined by RSM Audit Luxembourg S.à r.l., Pierre Leroy, réviseur d'entreprises agréé, in accordance
with the provisions of article 26-1 and 32-1 of the law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended, and
which report dated 22 July 2014 concludes as follows:
«On the basis of controls as described above, nothing has come to our attention that causes us to believe that the
value of the total receivables to be contributed retained at the time of the contribution in kind of EUR 860,910 is less
than the value of shares of DIMPLE HOLDING S.A. to be issued in exchange, i.e. 860,910 shares with a nominal value of
EUR 1 each and no share premium»
128103
L
U X E M B O U R G
This report, after having been signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary, will be attached
and recorded together with the present deed.
<i>Evidence of the Contributions existencei>
The contributions in kind are at the disposal of the Company, proof of which have been given to the undersigned
notary.
<i>Fourth resolution:i>
As a result of the above, it is unanimously resolved to amend article 5 of the Articles which should now be read as
follows:
“ Art. 5. The subscribed share capital is EUR 971,050 (nine hundred seventy-one thousand fifty Euros) divided into
971,050 (nine hundred seventy-one thousand fifty) shares of EUR 1 (one Euro) each."
No other amendment is made to the article.
There being no further business on the agenda, the Meeting was thereupon closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing
persons, this deed is worded in English followed by a French translation and that in case of any divergence between the
English and the French texts, the English version shall be prevailing.
Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, the chairman, they signed together with the notary the
present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille quatorze, le vingt-troisième jour du mois de juillet.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire établi à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné,
S'est tenue
une assemblée générale extraordinaire des associés (l' "Assemblée") de DIMPLE HOLDINGS S.A., une société ano-
nyme, constituée sous les lois de Luxembourg, ayant son siège social sis au 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, constituée par un acte notarié par le Maître soussigné le 29 novembre 2013, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 804 daté du 28 mars 2014, et immatriculée auprès du Registre
de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 184.054, (la "Société").
L'Assemblée est présidée par Hervé Hautin, employé privé, avec adresse professionnelle au 8, avenue de la Gare,
L-1610 Luxembourg.
Le président nomme comme secrétaire Sébastien Wiander, employé privé, avec adresse professionnelle au 8, avenue
de la Gare, L-1610 Luxembourg.
L' Assemblée élit comme scrutateur Laurent Huss, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 43, am
Duerf, L-8289 Kehlen.
Le bureau ayant ainsi été constitué, le président déclare et requiert du notaire d'acter ce qui suit:
I. Le nom des associés et le nombre des actions détenu par eux sont indiqués sur la liste de présence signée par les
associés présents, les pouvoirs des associés représentés et par les membres de l'Assemblée. Cette liste de présence et
ces procurations signées ''ne varietur'' par les personnes comparantes, les membres du bureau et le notaire soussigné
demeureront attachées au présent acte afin d'être soumises avec celui-ci aux formalités de l'enregistrement.
II.- Il ressort de la liste de présence que sur les 110.140 (cent dix mille cent quarante) actions, représentant la totalité
du capital social de la Société, toutes les actions sont présentes ou représentées à l'Assemblée. L'Assemblée est par
conséquent valablement constituée et peut valablement se prononcer sur l'ordre du jour connu par les associés présents
ou représentés.
III.- Les actionnaires représentés déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour de l'Assemblée et renoncer à leur
droit de recevoir la convocation préalable de telle sorte que l'Assemblée puisse valablement décider de tous les points
de l'ordre du jour.
IV. L'ordre du jour est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Renonciation au droit de convocation;
2. Augmentation du capital de la Société d'un montant de 860.910 EUR (huit cent soixante mille neuf cent dix Euros)
afin de l'augmenter de son montant actuel de 110.140 EUR (cent dix mille cent quarante Euros) à 971.050 EUR (neuf cent
soixante-onze mille cinquante Euros) par l'émission de 860.910 (huit cent soixante mille neuf cent dix) nouvelles actions
ordinaires d'une valeur nominale de 1 EUR (un Euro), devant être entièrement payés par voie d'apports en nature;
3. Souscription et paiement par l'apporteur de 860.910 (huit cent soixante mille neuf cent dix) nouvelles actions
ordinaires par voie d'apports en nature;
128104
L
U X E M B O U R G
4. Modification subséquente de l'article 5 des statuts de la Société; et
5. Divers.
Suite à l'approbation de ce qui précède par les Associés, les résolutions suivantes ont été adoptées:
<i>Première résolution:i>
Il a été unanimement décidé que les actionnaires renoncent à leur droit de recevoir la convocation préalable afférente
à la présente Assemblée. Les actionnaires reconnaissent avoir été suffisamment informés de l'ordre du jour de L'Assem-
blée, et considèrent avoir été valablement convoqués et en conséquence acceptent de délibérer et voter sur tous les
points figurant à l'ordre du jour. Il est en outre décidé que toute la documentation pertinente a été mise à la disposition
des actionnaires dans un délai suffisant afin de lui permettre un examen attentif de chaque document.
<i>Deuxième résolution:i>
Il a été unanimement décidé d’augmenter le capital social de la Société, d’un montant de 860.910 EUR (huit cent
soixante mille neuf cent dix Euros) afin de l'augmenter de son montant actuel de 110.140 EUR (cent dix mille cent quarante
Euros) à 971.050 EUR (neuf cent soixante-onze mille cinquante Euros) par l'émission de 860.910 (huit cent soixante mille
neuf cent dix) nouvelles actions ordinaires d'une valeur nominale de 1 EUR (un Euro) (les «Nouvelles Actions»), l'ensemble
devant être entièrement libéré par voie d'apports en nature tels que décrits ci-après (les «Apports»).
<i>Troisième résolution:i>
Il a été unanimement décidé d’accepter la souscription et le paiement par les apporteurs des Nouvelles Actions par
les Apports tel que décrit ci-après.
<i>Intervention - Souscription - Paiementi>
Interviennent les apporteurs, ici représentés par Hervé Hautin et Sébastien Wiander, prénommés, en vertu de pro-
curations données sous seing privé, qui déclarent souscrire aux Nouvelles Actions tel qu'il suit:
- Penshire Luxembourg S.à r.l.: 337.471 (trois cent trente-sept mille quatre cent soixante-onze) Nouvelles Actions;
- Orion S.C.: 203.962 (deux cent trois mille neuf cent soixante deux) Nouvelles Actions;
- Korafin S.A.S.: 55.452 (cinquante-cinq mille quatre cent cinquante-deux) Nouvelles Actions;
- Arnaud Million: 45.891 (quarante-cinq mille huit cent quatre-vingt-onze) Nouvelles Actions;
- Christophe Neumann: 39.773 (trente-neuf mille sept cent soixante-treize) Nouvelles Actions;
- Julien Leleu: 39.773 (trente-neuf mille sept cent soixante-treize) Nouvelles Actions;
- Yann Dremière: 22.945 (vingt-deux mille neuf cent quarante-cinq) Nouvelles Actions;
- Nathalie Couté: 3.824 (trois mille huit cent vingt-quatre) Nouvelles Actions;
- Cécile Coulon: 6.119 (six mille cent dix-neuf) Nouvelles Actions;
- Sylvie Rakinski: 7.648 (sept mille six cent quarante-huit) Nouvelles Actions;
- Laurence Chaumeil: 5.354 (cinq mille trois cent cinquante-quatre) Nouvelles Actions;
- Claire Pouliquen: 4.589 (quatre mille cinq cent quatre-vingt-neuf) Nouvelles Actions;
- Christian Depoortere: 3.824 (trois mille huit cent vingt-quatre) Nouvelles Actions;
- Paul Vaissié: 2.700 (deux mile sept cent) Nouvelles Actions; et
- Florence Fesneau: 81.585 (quatre-vingt-un mille cinq cent quatre-vingt-cinq) Nouvelles Actions.
Les Nouvelles Actions sont payés entièrement par les apporteurs par voie d'Apports tels que décrits ci-après.
<i>Description des Apportsi>
Les Apports faits par les apporteurs sont composés tel qu'il suit:
- une créance détenue par Penshire Luxembourg S.à r.l. d'un montant de 337.471 (trois cent trente-sept mille quatre
cent soixante-onze Euros);
- une créance détenue par Orion S.C. d'un montant de 203.962 (deux cent trois mille neuf cent soixante deux Euros);
- une créance détenue par Korafin S.A.S. d'un montant de 55.452 (cinquante-cinq mille quatre cent cinquante-deux
Euros);
- une créance détenue par Arnaud Million d'un montant de 45.891 (quarante-cinq mille huit cent quatre-vingt-onze
Euros);
- une créance détenue par Christophe Neumann d'un montant de 39.773 (trente-neuf mille sept cent soixante-treize
Euros);
- une créance détenue par Julien Leleu d'un montant de 39.773 (trente-neuf mille sept cent soixante-treize Euros);
- une créance détenue par Yann Dremière d'un montant de 22.945 (vingt-deux mille neuf cent quarante-cinq Euros);
- une créance détenue par Nathalie Couté d'un montant de 3.824 (trois mille huit cent vingt-quatre Euros);
- une créance détenue par Cécile Coulon d'un montant de 6.119 (six mille cent dix-neuf Euros);
128105
L
U X E M B O U R G
- une créance détenue par Sylvie Rakinski d'un montant de 7.648 (sept mille six cent quarante-huit Euros);
- une créance détenue par Laurence Chaumeil d'un montant de 5.354 (cinq mille trois cent cinquante-quatre Euros);
- une créance détenue par Claire Pouliquen d'un montant de 4.589 (quatre mille cinq cent quatre-vingt-neuf Euros);
- une créance détenue par Christian Depoortere d'un montant de 3.824 (trois mille huit cent vingt-quatre Euros);
- une créance détenue par Paul Vaissié d'un montant de 2.700 (deux mile sept-cent Euros); and
- une créance détenue par Florence Fesneau d'un montant de 81.585 (quatre-vingt-un mille cinq cent quatre-vingt-cinq
Euros).
Les Apports sont évalués à 860.910 EUR (huit cent soixante mille neuf cent dix Euros). Les Apports ont fait l'objet
d'un examen par RSM Audit Luxembourg S.à r.l., Pierre Leroy, réviseur d'entreprises agréé, en accord avec les dispositions
des articles 26-1 et 32-1 de la loi du 10 Aout 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, par un rapport daté
du 22 juillet 2014 qui conclut tel qu'il suit:
«Sur la base des contrôles décrits ci-avant, rien n'a été porté à notre attention nous laissant supposer que la valeur
de l'ensemble des créances apportées telle que retenue au moment de l'apport en nature ou 860.910 EUR serait moindre
que la valeur des actions de DIMPLE HOLDING S.A. émises en échange, c'est à dire 860.910 actions avec une valeur
nominale de 1 EUR chacune sans prime d'émission"
Ce rapport, après avoir été paraphé ne varietur par les comparants et le notaire, sera annexé au présent acte et
enregistré avec ledit acte.
<i>Preuve de l'Existence des Apportsi>
Les Apport en nature sont à la disposition de la Société, preuve en ayant été donnée au notaire soussigné.
<i>Quatrième résolution:i>
En conséquence des déclarations et résolutions précédentes, il a été unanimement décidé de modifier l'article 5 des
statuts de la Société, et de lui donner la teneur suivante:
" Art. 5. Le capital social souscrit de la Société est fixé à 971.050 EUR (neuf cent soixante-et-onze mille cinquante
Euros), divisé en 971.050 (neuf cent soixante-et-onze mille cinquante) actions de 1 EUR (un Euro) chacune."
Aucune autre modification n’est faite à l'article 5 des statuts de la Société.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est clôturée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par le présent acte qu'à la requête de la personne
comparante mentionnée ci-dessus, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la requête de la
même partie comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant au commencement de ce document.
Le document ayant été lu aux parties comparantes, celles-ci ont signé avec nous, le notaire, le présent acte original.
Signé: Hautin, Wiander, Huss, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 25 juillet 2014. Relation: EAC/2014/10427. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. Halsdorf.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2014117162/253.
(140135406) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2014.
Fondation Autisme-Luxembourg, Fondation.
Siège social: L-9766 Munshausen, 31, Duerefstrooss.
R.C.S. Luxembourg G 167.
<i>Comptes annuels et rapport du reviseur d'entreprises agrée au 31 décembre 2013i>
ACTIF
2013
EUR
2012
EUR
ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations corporelles (note 3)
Terrains . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
301.764,59
301.764,59
Constructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.831.582,25 1.875.683,84
Autres installations, outillage et mobilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112.819,61
66.072,24
Acomptes versés et immobilisations corporelles en cours
Constructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
129.050,72
23.345,00
2.375.217,17 2.266.865,67
128106
L
U X E M B O U R G
ACTIF CIRCULANT
Créances
Clients/usagers et comités rattachés
dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.900,79
18.013,38
Autres créances
dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80.493,82
98.014,70
Etats et autres collectivités publiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
400.889,34
298.442,96
493.283,95
414.471,04
Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux,
chèques et encaisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
902.999,31 2.027.737,23
1.396.283,26 2.442.208,27
COMPTES DE REGULARISATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19.818,23
50.739,03
3.791.318,66 4.759.812,97
<i>Bilan 31 décembre 2013i>
<i>(Exprimé en Euro)i>
PASSIF
2013
EUR
2012
EUR
FONDS PROPRES (note 4)
Fonds associatifs
Fonds associatifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61.973,38
61.973,38
Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24.666,67
-
Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
391.476,72
337.986,17
Résultat de l'exercice (note 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(34.927,54)
53.490,55
Subventions d'investissement et d'équipement (note 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.799.040,40 1.864.692,18
2.242.229,63 2.318.142,28
DETTES
Dettes envers des établissements de crédit (note 6)
dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32.169,26
34.692,76
dont la durée résiduelle est supérieure à un an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
345.183,21
377,947,37
377.352,47
412.640,13
Dettes sur achats et prestations de services
dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
168.349,98
168.763,49
Dettes fiscales et dettes au titre de la sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69.804,74
58.961,54
Dettes au titre de la sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
186.846,94
116,315,53
256.651,68
175.277,07
Etats et autres collectivités publiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
521.656,61 1.572.373,91
Autres dettes
dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
225.078,29
85.921,65
746.734,90 1.658.295,56
COMPTES DE REGULARISATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-
26.694,44
3.791.318,66 4.759.812,97
<i>Compte de profits et pertes 31 décembre 2013i>
<i>(Exprimé en Euro)i>
CHARGES
2013
EUR
2012
EUR
Autres charges externes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
921.334,31
831.716,72
Frais de personnel (note 7)
Salaires et traitements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.515.107,39 3.329.267,81
Charges sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
513.836,51
508.262,85
4.028.943,90 3.837.530,66
Corrections de valeur sur immobilisations corporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.920,41
138.118,50
Autres charges d'exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22.557,21
17.556,75
Intérêts et charges assimilées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.569,77
13.767,16
128107
L
U X E M B O U R G
Bénéfice de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-
53.490,55
5.089.325,60 4.892.180,34
PRODUITS
Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises (note 8) . . . . . . . .
429.897,78
424.407,67
Cotisations, dons, et collectes (note 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
288.231,14
190.984,57
Subventions d'exploitation (note 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.134.699,72 3.977.263,13
Autres produits d'exploitation (note 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94.752,70
130.166,74
Autres intérêts et produits assimilés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.482,32
18.732,87
Produits exceptionnels (note 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.334,40
150.625,36
Perte de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34.927,54
-
5.089.325,60 4.892.180,34
Les notes figurant en annexe font partie intégrante des comptes annuels
<i>Budget 2014i>
1. CHARGES PAR TYPE
2014
Charges de personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 247 400 €
Autres charges externes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
972 100 €
Corrections de valeur sur immobilisations corporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26 500 €
Intérêts et charges assimilées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 000 €
Excédent de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81 000 €
Total Charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 328 000 €
2. PRODUITS PAR TYPE
2014
Subventions d'exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 295 300 €
Dons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
303 700 €
Prestation de services, ventes,... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
456 000 €
Autres produits d'exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 500 €
Autres intérêts et produits assimilés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 500 €
Dons exceptionnels (héritages) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
260 000 €
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 328 000 €
C. SCHMIT / C. FAYOT
<i>Président / Trésorièrei>
Référence de publication: 2014117260/106.
(140134959) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2014.
Senior European Loan Fund SCA-SIF, Société en Commandite par Actions - Fonds d'Investissement Spé-
cialisé.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 169.723.
In the year two thousand and fourteen, on the twenty second of day of July,
Before us, Me Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Danièle Maton, employee at AEW Europe S.à r.l., with professional address at 5 allée Scheffer, L-2520 Luxembourg,
acting in her capacity as special proxyholder of the General Partner of Senior European Loan Fund SCA-SIF, a Société
en Commandite par Actions- Fonds d'Investissement Spécialisé governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,
with registered office at 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, incorporated on 18 June 2012 pursuant to a deed of Me
Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations. (the "Mémorial C") number 1689, dated 5 July 2012, and whose articles of incorporation (the
"Articles") have been amended for the last time pursuant to a deed dated 18 November 2013 before the notary prenamed
and published in the Mémorial C number 23 dated 3 January 2014, and registered with the Luxembourg Register of
Commerce and Companies under number B 169.723 (the "Company"),
by virtue of the authority conferred on her by resolutions adopted on 6 June 2014 by the board of managers of Senior
European Loan Management (acting as general partner of the Company (the "General Partner"), a copy of which reso-
128108
L
U X E M B O U R G
lutions, signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed
to be filed at the same time with the registration authorities.
Said appearing person, acting in her said capacity, has requested the undersigned notary to record the following de-
clarations and statements:
I. That, pursuant to article 5.1 of the Articles, the issued share capital of the Company is presently set at eleven million
three hundred and eight thousand nine hundred twenty-three Euros (EUR 11,308,923.-), divided into one (1) management
share in Senior European Loan Fund SCA-SIF- Senior European Loan Fund 1 (the "Compartment") held by the General
Partner and eleven million three hundred and seven thousand nine hundred twenty-three (11,307,923) Class A Ordinary
Shares held by Class A Limited Shareholders in the Compartment and nine hundred ninety-nine (999) Class B Ordinary
Shares in the Compartment held by the General Partner as Class B Limited Shareholder.
II. That pursuant to article 5 of the Articles, the un-issued but authorised share capital of the Company has been fixed
at fifty million Euro (EUR 50,000,000.-) and that pursuant to the same article 5, the General Partner has been authorised
to increase the issued share capital of the Company by creating and issuing new shares.
III. That the Board, during the same meeting held on 6 June 2014, has resolved to cancel any preferential subscription
rights and to approve the issuance of six million four hundred fifty thousand one hundred twenty (6,450,120) new Class
A Ordinary Shares to the existing shareholders, upon receipt of satisfactory evidence of receipt of the entire amount of
their respective parts of the drawn Commitments from the custodian bank of the Company; such newly issued Class A
Ordinary Shares to be divided as follows among the various shareholders as follows:
i. Two million nine hundred ninety-two thousand six hundred eighty-six (2,992,686) new Class A Ordinary Shares to
be issued to CNP-EVJ Fonds General Ecureuil Vie and CNP-272 Trésor Vie, in consideration for the payment of twenty-
nine million nine hundred twenty-six thousand eight-hundred sixty Euros (EUR 29,926,860), two million nine hundred
ninety-two thousand six hundred eighty-six Euros (EUR 2,992,686) of which to be allocated to the share capital of the
Compartment and the remaining twenty-six million nine hundred thirty-four thousand one hundred seventy-four Euros
(EUR 26,934,174) to be booked as share premium;
ii. Three hundred ninety-nine thousand and twenty-five (399,025) new Class A Ordinary Shares to be issued to ABP
Vie, in consideration for the payment of three million nine hundred ninety thousand two hundred fifty Euros (EUR
3,990,250), three hundred ninety-nine thousand and twenty-five Euros (EUR 399,025) of which to be allocated to the
share capital of the Compartment and the remaining three million five hundred ninety-one thousand two hundred twenty-
five Euros (EUR 3,591,225) to be booked as share premium; and
iii. One million eight hundred eighty-one thousand two hundred eighty-five (1,881,285) new Class A Ordinary Shares
to be issued to Predica-Predica Actif Long Terme and Predica-Predica Predige, in consideration for the payment of
eighteen million eight hundred and twelve thousand eight hundred fifty Euros (EUR 18,812,850), one million eight hundred
eighty-one thousand two hundred eighty-five Euros (EUR 1,881,285) of which to be allocated to the share capital of the
Compartment and the remaining sixteen million nine hundred thirty-one thousand five hundred sixty-five Euros (EUR
16,931,565) to be booked as share premium, and
iv. Three hundred ninety-nine thousand and twenty five (399,025) new Class A Ordinary Shares to be issued to Ageas
France, in consideration for the payment of three million nine hundred ninety thousand two hundred and fifty Euros (EUR
3,990,250), three hundred ninety-nine thousand and twenty-five Euros (EUR 399,025) of which to be allocated to the
share capital of the Compartment and the remaining three million five hundred ninety-one thousand two hundred twenty-
five Euros (EUR 3,591,225) to be booked as share premium; and
v. One hundred ninety-nine thousand five hundred thirteen (199,513) new Class A Ordinary Shares to be issued to
BPCE Assurances, in consideration for the payment of one million nine hundred ninety-five thousand one hundred thirty
Euros (EUR 1,995,130), one hundred ninety-nine thousand five hundred thirteen Euros (EUR 199,513) of which to be
allocated to the share capital of the Compartment and the remaining one million seven hundred ninety-five thousand six
hundred seventeen Euros (EUR 1,795,617) to be booked as share premium; and
vi. Five hundred seventy-eight thousand five hundred ninety-six (578,586) new Class A Ordinary Shares to be issued
to Caumartin Financement à l'Economie, in consideration for the payment of five million seven hundred eighty-five thou-
sand nine hundred sixty Euros (EUR 5,785,860), five hundred seventy-eight thousand five hundred ninety-six Euros (EUR
578,586) of which to be allocated to the share capital of the Compartment and the remaining five million two hundred
and seven thousand three hundred sixty-four Euros (EUR 5,207,274) to be booked as share premium; and
IV. That all these Class A Ordinary Shares have been entirely subscribed by the aforesaid subscribers and fully paid up,
together with the aggregate share premium, by contributions in cash to the Company as confirmed on 16 June 2014, so
that the total amount of sixty-four million five hundred and one thousand two hundred Euros (EUR 64,501,200) repre-
senting the amount of the abovementioned capital increase of six million four hundred fifty thousand one hundred and
twenty (EUR 6,450,120) and an aggregate share premium in an amount of fifty-eight million fifty-one thousand and eighty
Euros (EUR 58,051,080) is at the free disposal of the Company, as was evidenced to the undersigned notary by presen-
tation of the supporting documents for the relevant payments.
V. That the Board, during the same meeting held on 6 June 2014, and in accordance with the authority conferred to
it pursuant to article 5 of the Articles, has decided to increase the issued share capital by an amount of six million four
hundred fifty thousand one hundred twenty Euros (EUR 6,450,120.-).
128109
L
U X E M B O U R G
VI. That as a consequence of the abovementioned capital increase of the issued share capital, the first paragraph of
article 5 of the Articles is therefore amended and shall read as follows:
" 5.1. The Company's subscribed share capital is set at seventeen million seven hundred fifty-nine thousand forty-three
Euros (EUR 17,759,043.-) represented by one (1) Management Share held by the General Partner in Senior European
Loan Fund SCA-SIF- Senior European Loan Fund 1 and seventeen million seven hundred fifty-eight thousand forty-three
(17,758,043) Class A Ordinary Shares held by Class A Limited Shareholders in Senior European Loan Fund SCA-SIF-
Senior European Loan Fund 1 and nine hundred ninety-nine (999) Class B Ordinary Shares held by the General Partner
in Senior European Loan Fund SCA-SIF- Senior European Loan Fund 1, all Shares being fully paid up. These Ordinary
Shares are redeemable in accordance with the provisions of article 49-8 of the 1915 Law and these Articles of Incorpo-
ration."
<i>Expensesi>
The expenses, incumbent on the company and charged to it by reason of the present deed, are estimated at approxi-
mately seven thousand Euros (EUR 7,000.-)
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing
person, the present deed is worded in English only.
Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, who is known to the notary by his surname, first name, civil
status and residence, the said person signed together with the notary the present original deed.
Signé: D. MATON, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils le 24 juillet 2014. Relation: LAC/2014/34813. Reçu soixante quinze euros (EUR
75,-).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
Référence de publication: 2014114434/104.
(140133570) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2014.
Sea-Invest Afrique S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 133.563.
<i>Extrait de l'assemblée générale annuelle du 11 juillet 2014i>
L'assemblée générale décide de renouveler les mandats des administrateurs suivants:
Monsieur Jean BENAIM, demeurant au 31, route suisse, CH-1297 Founex/Vaux;
Pour une durée de 1 an, soit jusqu'à l'Assemblée Générale qui statue sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre
2014.
Monsieur Philippe VAN DE VYVERE, demeurant au 44, Kasteellaan, B-9921 Lovendegem;
Pour une durée de 1 an, soit jusqu'à l'Assemblée Générale qui statue sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre
2014.
Monsieur Marc-Yves BLANPAIN, demeurant au 28, avenue du Manoir, B-1410 Waterloo;
Pour une durée de 1 an, soit jusqu'à l'Assemblée Générale qui statue sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre
2014.
Monsieur Olivier MARCERON, demeurant au 87, boulevard Suchet, F-75016 Paris;
Pour une durée de 1 an, soit jusqu'à l'Assemblée Générale qui statue sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre
2014.
Monsieur Gérard LONGUET, demeurant au 56, rue du Chateaudun, F-75009 Paris;
Pour une durée de 1 an, soit jusqu'à l'Assemblée Générale qui statue sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre
2014.
Monsieur Xavier VAN DE SOMPELE, demeurant au 9, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg.
Pour une durée de 1 an, soit jusqu'à l'Assemblée Générale qui statue sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre
2014.
L'assemblée générale décide de renouveler le mandat de réviseur d'entreprises agréé de la société RSM Audit Lu-
xembourg S.à r.l., société immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B113621,
ayant son siège social à L-1116 Luxembourg au 6, rue Adolphe.
Le mandat du Réviseur d'entreprises agréé viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale d'approbation des
comptes clos le 31 décembre 2014 à tenir en 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
128110
L
U X E M B O U R G
FIDUO
Référence de publication: 2014110974/34.
(140132695) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2014.
New Quasar S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.400,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 8, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 91.832.
L'an deux mille quatorze, le seize juillet.
Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg,
Ont comparu:
1) Monsieur Sandro LATERZA, demeurant à L-8081 Bertrange, 56, rue de Mamer.
2) Monsieur Salvatore SARACENO, demeurant à L-1865 Luxembourg, 1, rue Jean-Pierre Koenig.
Lesquels comparants agissant en leur qualité de seuls associés de la société à responsabilité limitée NEW QUASAR
S.à r.l., avec siège social à L-2310 Luxembourg, 8, avenue Pasteur, inscrite au Registre de commerce et des sociétés sous
le numéro B 91832 («la Société»), constituée suivant acte notarié, en date du 15 janvier 2003, publié au Mémorial, Recueil
Spécial C, numéro 369 du 4 avril 2003,
ont requis le notaire instrumentant d'acter la cession de parts suivante:
I) Monsieur Sandro LATERZA, prénommé, déclare céder à Monsieur Salvatore SARACENO, prénommé, qui accepte,
les 51 (cinquante-et-une) parts sociales qu'il détient dans la Société, au prix de cession convenu entre parties, soit au prix
de EUR 75.000.- (soixante-quinze mille euros).
Le prix de cession a été payé par le cessionnaire au cédant dès avant les présentes, ce dont le cédant donne bonne et
valable quittance.
Le cessionnaire est propriétaire des parts sociales à lui cédées et il aura droit aux revenus et bénéfices dont elles
seront productives à compter de ce jour. Il est subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées à
partir du même jour.
Le cessionnaire déclare en outre avoir une parfaite connaissance de la situation financière de la Société.
La cession de parts est acceptée au nom de la Société conformément à l'article 1690 du Code Civil par son gérant
Monsieur Sandro Laterza, prénommé.
Monsieur Sandro Laterza, prénommé, déclare ensuite donner sa démission en tant que gérant technique de la Société.
Suite à cette cession de parts, les 100 (cent) parts sociales représentatives du capital social sont détenues par Monsieur
Salvatore Sareceno, associé unique de la Société.
<i>Résolution de l'associé unique.i>
Ensuite l'associé unique a pris les résolutions suivante:
<i>Première résolutioni>
L'associé unique accepte la démission de Sandro Laterza, prénommé, de sa fonction de gérant technique de la Société
et lui donne décharge pour l'exécution de son mandat.
<i>Deuxième résolutioni>
L'associé unique décide de nommer comme gérant de la Société:
Monsieur Salvatore SARACENO, demeurant à L-1865 Luxembourg, 1, rue Jean-Pierre Koenig, né à Augusta, Italie, le
2 janvier 1980.
Il a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société dans toutes les circonstances par sa signature indivi-
duelle.
<i>Troisième résolution:i>
L'associé unique décide de modifier l'article six des statuts comme suit:
« Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euro (EUR 12.400.-) représenté par cent (100) parts
sociales d'une valeur nominale de cent vingt-quatre euro (EUR 124.-) chacune, entièrement libérées.»
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: S. LATERZA, S. SARACENO et H. HELLINCKX.
128111
L
U X E M B O U R G
Enregistré à Luxembourg A.C., le 22 juillet 2014. Relation: LAC/2014/34387. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 28 juillet 2014.
Référence de publication: 2014115399/54.
(140135521) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2014.
Montagna, Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 170.980.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 16 juillet 2014, statuant sur les comptes annuels au
31 décembre 2012 et au 31 décembre 2013 que:
Sont réélus pour une période de six ans, leurs mandats prenant fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant
sur les comptes annuels au 31 décembre 2019:
- Monsieur Thierry JACOB, en qualité d'Administrateur
- Monsieur Jean-Hugues DOUBET, en qualité d'Administrateur
- Monsieur Michele ROMERIO, en qualité de Commissaire aux comptes
Madame Mireille GEHLEN, ne sollicitant pas son renouvellement de mandat en qualité d'Administrateur, l'Assemblée
Générale décide d'élire en son remplacement et ceci pour une période de six ans, son mandat prenant fin lors de l'As-
semblée Générale statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2019:
- Madame Martine STIEVEN, née le 08 mai 1968 à Aumetz (France), demeurant professionnellement au 412F, route
d'Esch, L-2086 Luxembourg
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2014110797/21.
(140132376) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2014.
Alcentra Mezzanine QPAM S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 114.912.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 3 juin 2014:i>
- Monsieur Simon Barnes a démissionné de ses fonctions en tant que gérant de la Société avec effet au 14 mai 2014.
- Monsieur Ian Kent a démissionné de ses fonctions en tant que gérant de la Société avec effet au 14 mai 2014.
- Nomination de Madame Kathryn O'Sullivan, résidante professionnellement au 47 Avenue John F. Kennedy, L-1855
Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, née le 28 juin 1963 à San Jose, CA, États-Unis, en qualité de gérant avec effet
au 14 mai 2014 et pour une durée indéterminée.
- Nomination de Monsieur Yves Cheret, résidant professionnellement au 9 A, Boulevard Prince Henri, L-1724 Lu-
xembourg, Grand Duché de Luxembourg, né le 1
er
mai 1966 à Eupen, Belgique, en qualité de gérant avec effet au 14 mai
2014 et pour une durée indéterminée.
- Nomination de Monsieur Frits Carlsen, résidant professionnellement au 47 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Lu-
xembourg, Grand Duché de Luxembourg, né le 4 septembre 1958 à Copenhagen, Danemark, en qualité de gérant avec
effet au 14 mai 2014 et pour une durée indéterminée.
Le conseil de gérance se compose dorénavant comme suit:
- M. Frits Carlsen, gérant
- M. Yves Cheret, gérant
- M. Iain MacLoed, gérant
- Mme. Kathryn O' Sullivan, gérant
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014112955/26.
(140133696) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2014.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
128112
Alcentra Mezzanine QPAM S.à r.l.
Dimple Holding S.A.
Dominium Holdco S.à r.l.
Energreen Investment S.à r.l.
Eurasian Resources Group
Euroland Properties S.A.
Fa Capital S.A.
Fondation Autisme-Luxembourg
JER Manhattan S.à r.l.
JER Trafalgar S.à r.l.
KAILUA S.A.
K.B.S. Construction S.A.
Kennametal Luxembourg Holding S.à r.l.
Kikuoka Luxembourg S.A.
Kinetek Luxco GP S.à r.l. & Partners S.C.S.
Kiwi Media
KoBauLux S.A.
Koudourrou S.A.
KR Real Estate Corporation S.à r.l.
Kwasa Europe S.à r.l.
La Languette S.à r.l.
L.B.T.V. s.à r.l.
Le Comptoir du Pain S.A.
Leopard Germany Property 1 S.à r.l.
Leopard Germany Property 2 S.à r.l.
Leopard Germany Property 3 S.à r.l.
Leopard Germany Property Ed 2 S.à.r.l.
Leopard Germany Property Ed 3 S.à.r.l.
Leopard Germany Property Ed 4 S.à.r.l.
Leopard Germany Property ME 2 S.àr.l.
Links Bidco S.à r.l. Propco 1
Links Bidco S.à r.l. Propco 10
Links Bidco S.à r.l. Propco 11
Links Bidco S.à r.l. Propco 12
Links Bidco S.à r.l. Propco 2
Links Bidco S.à r.l. Propco 3
Links Bidco S.à r.l. Propco 4
Links Bidco S.à r.l. Propco 5
Links Bidco S.à r.l. Propco 6
Links Bidco S.à r.l. Propco 7
Links Bidco S.à r.l. Propco 8
Links Bidco S.à r.l. Propco 9
Lombard Odier Investment Managers Private Equity Investments
Lone Star Capital Investments S.à r.l.
Luxembourg Airport Centre
Luxembourg Boulevard Royal Centre
Lux Flex
Moda Inc. s.à.r.l.
Montagna
New Quasar S.à.r.l.
Ozero Group S.A.
PremTech
Private Market Opportunities Fund SICAV SIF S.A.
Sea-Invest Afrique S.A.
Senior European Loan Fund SCA-SIF
WP Merger S. à r.l.
WP Roaming III S.à r.l.
WP Roaming I S.à r.l.
X-Rite Holdings S.à r.l.