logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2630

29 septembre 2014

SOMMAIRE

Algohal S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126205

Alison Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

126205

Alma Consultancy S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

126205

CIGOGNE Management S.A.  . . . . . . . . . . .

126238

E.L.E. Lux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126198

Emuto Global Capital S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

126198

F.P.T. Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126199

Future Investments 2005 S.A.  . . . . . . . . . . .

126202

Grel S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126203

Haute Horlogerie Benelux S.A. . . . . . . . . . .

126240

Helpling Group Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . .

126214

Henderson Horizon Fund  . . . . . . . . . . . . . . .

126240

High Gate Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

126210

Lux-Protect Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126195

LUX-Trading S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126195

Magma Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126197

Maison Stemper  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126196

MALG S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126204

Mangrove III Management S.A. . . . . . . . . . .

126198

Mangrove III Sub Investments S.à r.l.  . . . .

126196

Mangrove Russia I (S.C.A.), SICAR  . . . . . .

126194

Mediterranean Strategical Investments

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126195

MENA Joint Investment Fund S.C.A., SI-

CAV-SIF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126204

Meridiam Eastern Europe S.à r.l.  . . . . . . . .

126195

Meridiam Infra Invest Brownfield S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126196

Méridiam Infrastructure Finance S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126195

Midwest Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126196

Morgan Stanley Derivative Products Glo-

bal S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126197

Muzinich European Private Debt Fund  . . .

126204

Mythology European Real Estate Fund

S.C.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126197

Point Blank Promotions S.A.  . . . . . . . . . . . .

126239

Portlux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126239

Quinta Greentech Investments S.à r.l.  . . .

126206

Sablon S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126200

Sacma International Group S.A.  . . . . . . . . .

126194

Saft Finance S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126199

Sagra Holdings  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126204

Saint-Gobain Abrasives S.A. . . . . . . . . . . . . .

126199

Samba Luxco S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126199

S.à r.l. BDPX  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126194

School 1 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126203

SciCan Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

126203

Sheet Anchor LuxHoldCo S.à r.l.  . . . . . . . .

126202

Sigla Luxembourg Holdings S.à r.l.  . . . . . .

126203

SIGNA R.E.C.P. Development "Tuchlau-

ben" Beteiligung S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

126194

Signode Industrial Group Holdings Lux S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126212

Silicon Motion Technology (Luxembourg)

Limited  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126201

Skyline Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

126200

Sofinga S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126200

Spark Energy Solutions S.à r.l. . . . . . . . . . . .

126237

Stidia S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126200

SuDel Invest S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126200

SwanCap GP, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126194

Thagol S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126201

Thalia Alternative SICAV  . . . . . . . . . . . . . . .

126201

Theia SICAV SIF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126202

Tlux Participations S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

126238

126193

L

U X E M B O U R G

S.à r.l. BDPX, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3474 Dudelange, rue Auguste Liesch.

R.C.S. Luxembourg B 30.853.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 21 juillet 2014.

Référence de publication: 2014107910/10.
(140128145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2014.

Sacma International Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 72.159.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juillet 2014.

Référence de publication: 2014107913/10.
(140128530) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2014.

SwanCap GP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 179.410.

Der Jahresabschluss vom 31.12.2013 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg Investment Solutions S.A.
Unterschrift

Référence de publication: 2014107936/11.
(140128572) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2014.

SIGNA R.E.C.P. Development "Tuchlauben" Beteiligung S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 142.172.

Der Jahresabschluss vom 31.12.2013 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Compliance Partners S.A.
Signature

Référence de publication: 2014107949/11.
(140128591) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2014.

Mangrove Russia I (S.C.A.), SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société

d'Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 175.088.

Les comptes Annuels du 20 décembre 2012 au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 mai 2014.

Référence de publication: 2014109699/12.
(140130998) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2014.

126194

L

U X E M B O U R G

Lux-Protect Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.

R.C.S. Luxembourg B 110.989.

Les bilans de LUX-PROTECT FUND, SICAV du 1 

er

 avril 2013 au 31 mars 2014, enregistrés à Esch/Al. A.C., le 22

JUIL. 2014. Relation: EAC / 2014 / 10164, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014109674/10.
(140130553) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2014.

LUX-Trading S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4367 Belvaux, 1, avenue du Swing.

R.C.S. Luxembourg B 109.562.

Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Référence de publication: 2014109676/10.
(140130761) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2014.

Méridiam Infrastructure Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 116.694.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Meridiam Infrastructure Finance S.à.r.l.
CACEIS Bank Luxembourg

Référence de publication: 2014109691/11.
(140130779) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2014.

Meridiam Eastern Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 176.996.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Meridiam Eastern Europe S.à.r.l.
Caceis Bank Luxembourg

Référence de publication: 2014109702/11.
(140130780) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2014.

Mediterranean Strategical Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 121.650.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

MEDITERRANEAN STRATEGICAL INVESTMENTS S.A.
Signatures
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2014109730/12.
(140130575) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2014.

126195

L

U X E M B O U R G

Midwest Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 115.204.

<i>Rectificatif du dépôt numéro L140128894 déposé le 23/07/2014

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014109706/10.
(140130866) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2014.

Meridiam Infra Invest Brownfield S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 179.203.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Meridiam Infra Invest Brownfield S.à.r.l.
CACEIS Bank Luxembourg

Référence de publication: 2014109703/11.
(140130781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2014.

Maison Stemper, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7562 Mersch, 2, Um Iecker.

R.C.S. Luxembourg B 10.495.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Monsieur PAUL BESCH
<i>Le gérant technique

Référence de publication: 2014109694/11.
(140130456) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2014.

Mangrove III Sub Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 147.445.

<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire, tenue à Luxembourg le 30 avril 2014

L'Assemblée Générale Ordinaire tenue au Luxembourg le 30 avril 2014 décide de renouveler avec effet immédiat

jusqu'à la prochaine assemblée générale qui aura lieu en 2015 les mandats suivants:

<i>- des trois gérants suivants:

* Mr. Gérard LOPEZ
* Mr. Mark TLUSZCZ
* Mr. Hans-Jürgen SCHMITZ

<i>- du commissaire aux comptes:

* Deloitte S.A.
Les gérants sont au 30 avril 2014:
Gérard LOPEZ, Mark TLUSZCZ et Hans-Jürgen SCHMITZ, ayant leur adresse professionnelle au 31, Boulevard Joseph

II, L-1840 Luxembourg.

Luxembourg, le 24 juillet 2014.

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE
Société Anonyme

Référence de publication: 2014109697/22.
(140130728) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2014.

126196

L

U X E M B O U R G

Mythology European Real Estate Fund S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 186.915.

Veuillez prendre note que le siège social du membre de conseil de surveillance, la société à responsabilité limitée

COMCOLUX S.à r.l., se trouve dorénavant au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 24.7.2014.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour Mythology European Real Estate Fund S.C.A.
Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2014109716/13.
(140131404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2014.

Morgan Stanley Derivative Products Global S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.250.000,00.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 136.764.

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglister, Grand-Duché de

Luxembourg, en date du 14 février 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 794 du 2
avril 2008.

Les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Morgan Stanley Derivative Products Global S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2014109711/15.
(140130953) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2014.

Magma Capital, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 152.395.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait

Il résulte d'un acte de clôture de liquidation reçu par le notaire Maître Martine SCHAEFFER, de résidence à Luxem-

bourg, en date du 17 juillet 2014, enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 18 juillet 2014, LAC/2014/33927, aux droits
de soixante-quinze euro (75,- EUR), que la société anonyme sous la forme d'une société d'investissement à capital variable
- fonds d'investissement spécialisé Magna Capital (en liquidation), ayant son siège social à 4, rue Jean Monnet, L-2180
Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 152.395, constitué en date du 31 mars
2010 par acte de Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, numéro 840 du 23
avril 2010.

La société a été mise en liquidation par acte du notaire instrumentaire en date du 20 juin 2014, non encore publié au

Mémorial C.

L'assemblée générale approuvé les rapports du commissaire à la liquidation et du liquidateur; et
en conséquence l'assemblée générale a prononcé la clôture de la liquidation de la société Magna Capital (en liquidation).
Les livres et documents sociaux de la Société seront déposés pendant cinq (5) ans à l'ancien siège social, au 4, rue Jean

Monnet, L-2180 Luxembourg.

L'assemblée générale décide en outre que les sommes et valeurs revenant aux créanciers ou aux membres seront

déposés séquestre de Sal. Oppenheim jr &amp; Cie. Luxembourg S.A.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juillet 2014.

Référence de publication: 2014109693/26.
(140131561) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2014.

126197

L

U X E M B O U R G

Emuto Global Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: AUD 19.786,25.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 3, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 130.172.

Lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 27 juin 2014, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Nomination de Torsten Klaas, avec adresse professionnelle au 3, rue Jean Monnet, L - 2180 Luxembourg, au mandat

de «Geschäftsführer», avec effet au 1 

er

 juin 2014 et pour une durée indéterminée;

2. Acceptation de la démission de Frank Hamen, avec adresse professionnelle au 3, rue Jean Monnet, L-2180 Luxem-

bourg de son mandat de «Geschäftsführer», avec effet au 31 mai 2014;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 juillet 2014.

Référence de publication: 2014113276/15.
(140133585) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2014.

E.L.E. Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 95.201.

Par décision du Conseil d'Administration tenu le 18 juillet 2014 au siège social de la société, il a été décidé:
- d'accepter la démission de Monsieur Andrea Giovanni Carini, résidant professionnellement au 20 rue de la Poste,

L-2346 Luxembourg, de sa fonction d'administrateur, avec effet immédiat;

- de coopter comme nouvel administrateur, avec effet immédiat, CL Management S.A., ayant son siège social au 20

rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, son mandat ayant comme échéance celui de son prédécesseur;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

E.L.E. Lux S.A.
Société anonyme
Signature

Référence de publication: 2014113265/16.
(140132999) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2014.

Mangrove III Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 140.594.

<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire, tenue à Luxembourg le 30 avril 2014

L'Assemblée Générale Ordinaire tenue au Luxembourg le 30 avril 2014 décide de renouveler avec effet immédiat

jusqu'à la prochaine assemblée générale qui aura lieu en 2015 les mandats suivants:

<i>- des trois administrateurs suivants:

* Mr. Gérard LOPEZ
* Mr. Mark TLUSZCZ
* Mr. Hans-Jürgen SCHMITZ

<i>- du Réviseur d'Entreprises:

* Deloitte S.A.
Les Administrateurs sont au 30 avril 2014:
Gérard LOPEZ, Mark TLUSZCZ et Hans-Jürgen SCHMITZ, ayant leur adresse professionnelle au 31, Boulevard Joseph

II, L-1840 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juillet 2014.

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE
Société Anonyme

Référence de publication: 2014109724/23.
(140130729) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2014.

126198

L

U X E M B O U R G

Saft Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 13.000.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 96.506.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juillet 2014.

Référence de publication: 2014107914/10.
(140128529) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2014.

Samba Luxco S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 2.130.000,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 129.304.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juillet 2014.

Référence de publication: 2014107916/10.
(140129004) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2014.

Saint-Gobain Abrasives S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4930 Bascharage, 190, boulevard J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 6.491.

Les comptes annuels de la compagnie de Saint-Gobain au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg au titre de l’article 314 de la loi du 19 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Nicolas Gouguet
<i>Directeur Financier

Référence de publication: 2014108930/12.
(140130076) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2014.

F.P.T. Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 53.084.

<i>Extrait des décisions de l'actionnaire unique prises en date du 15 mai 2014

En date du 15 mai 2014, l'actionnaire unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
1. Accepter la démission de Madame Magali Fetique en tant qu'administrateur de la Société, avec date effective au 26

mars 2014.

2. Accepter la démission de Monsieur Jean-Marie Bettinger en tant qu'administrateur de la Société, avec date effective

au 15 mai 2014.

3. Nommer Madame Estelle Wanssy, née le 7 juillet 1979 à Fresnes (France) résidant professionnellement au 4, rue

Albert Borschette L-1246 Luxembourg, en tant qu'administrateur de la Société, avec effet au 26 mars 2014, et pour une
durée limitée de 6 ans.

4. Nommer Madame Marta Basso, née le 30 janvier 1984 à Cittadella (Italie) résidant professionnellement au 4, rue

Albert Borschette L-1246 Luxembourg, en tant qu'administrateur de la Société, avec effet au 15 mai 2014, et pour une
durée limitée de 6 ans.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juillet 2014.

FPT HOLDING SA

Référence de publication: 2014113312/22.
(140133537) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2014.

126199

L

U X E M B O U R G

Skyline Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 76.214.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014108952/9.
(140129372) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2014.

Sofinga S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 133.420.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014108921/9.
(140129390) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2014.

Sablon S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7535 Mersch, 14, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 80.212.

Les documents de clôture de l'année 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 22 juillet 2014.

Référence de publication: 2014108927/10.
(140129070) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2014.

SuDel Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.000.000,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 98.995.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 juillet 2014.

Référence de publication: 2014108926/10.
(140129472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2014.

Stidia S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1259 Senningerberg, 15, Zone Industrielle Breedewues.

R.C.S. Luxembourg B 155.208.

EXTRAIT

En date du 10 juillet 2014, les actionnaires, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris les réso-

lutions suivantes:

1. Démission de Monsieur Nicolas VAN BEEK de son poste d'administrateur avec effet au 20 juillet 2014.
2.  Nomination  de  Madame  Irdelle  LAGNIDE  domicilié  au  143,  rue  de  Luxembourg  à  L-8077  Bertrange  au  poste

d'administrateur avec effet au 21 juillet 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 10 Juillet 2014.

<i>Les actionnaires

Référence de publication: 2014108967/16.
(140129644) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2014.

126200

L

U X E M B O U R G

Silicon Motion Technology (Luxembourg) Limited, Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 179.305.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions écrites prises par l'associé de la Société en date du 24 juillet 2014 que:
- La démission de Monsieur Benoît BAUDUIN, de son poste de gérant de classe B, avec effet au 18 juillet 2014, a été

acceptée;

- A été nommé en tant que gérant de classe B, avec effet au 18 juillet 2014, et ce pour une durée illimitée:
* Monsieur Marc CHONG KAN, né le 24 août 1964 à Paris, France, demeurant professionnellement au 16, avenue

Pasteur, L-2310 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juillet 2014.

Référence de publication: 2014109943/17.
(140130818) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2014.

Thalia Alternative SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 100.470.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Annuelle du 12 mai 2014

Sont réélus au Conseil d'Administration pour une période se terminant à l'Assemblée Générale Annuelle de 2015:
- Mr Paolo TAMBURINI, Membre du Conseil d'administration
Via Peri 21, CH-6900 Lugano
- Mr Raffaele BARTOLI, Président du Conseil d'administration
6, Avenue Marie-Thérèse, L- 2132 Luxembourg
- Mr Matthieu FEFFER, Membre du Conseil d'administration
7-9, boulevard Haussmann, F-75009 Paris
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour THALIA ALTERNATIVE SICAV
UBS Fund Services (Luxembourg) S.A

Référence de publication: 2014114556/18.
(140133393) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2014.

Thagol S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 86.451.

<i>Extrait des décisions prises par l'assemblée générale de l'associée en date du 16 juin 2014

1. Mme Katia CAMBON a démissionné de son mandat de gérante.
2. Mme Virginie DECONINCK, administrateur de sociétés, née à Rocourt (Belgique), le 11 octobre 1976, demeurant

professionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommée gérante pour une durée indéterminée.

3. Le siège a été transféré de L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, à L-2453 Luxembourg,

6, rue Eugène Ruppert.

Veuillez noter que l'adresse professionnelle de Mme Chantal SCHMIT et de M. Hans DE GRAAF, gérants, se situe

désormais au L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

Luxembourg, le 28 Juillet 2014.

Pour extrait et avis sincères et conformes
<i>Pour THAGOL S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2014114554/19.
(140133194) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2014.

126201

L

U X E M B O U R G

Sheet Anchor LuxHoldCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 177.791.

EXTRAIT

Les résolutions suivantes ont été adoptées par l'Associé unique en date du 21 juillet 2014:
- La démission de En Lee en tant que gérant A de la Société est acceptée avec effet immédiat;
- Barbara Neuerburg, née le 18 mai 1979 à Krumbach (Allemagne), avec adresse professionnelle au 15 rue Edward

Steichen, L-2540 Luxembourg, a été élue nouveau gérant A de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée
indéterminée.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2014109939/15.
(140131609) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2014.

Theia SICAV SIF, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 154.965.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale annuelle du 28 mai 2014:

Sont ré-élus au conseil d'administration pour une période se terminant à l'assemblée générale annuelle de 2015:
- Mr Paolo Tamburini, président du conseil d'administration,
Via Péri 21, CH-6900 Lugano, Suisse.
- Mr Nicola Battalora, membre du conseil d'administration,
6 Avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg.
- Mr Raffaele Bartoli, membre du conseil d'administration,
6 Avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Theia SICAV SIF
UBS Fund Services (Luxembourg) S.A

Référence de publication: 2014114558/18.
(140133015) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2014.

Future Investments 2005 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 112.185.

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire de la Société tenue en date du 24 juillet 2014 que:
- Les démissions de Monsieur Benoît BAUDUIN, administrateur et Président du Conseil d'Administration de la Société,

et de Monsieur Luc GERONDAL, administrateur de la Société, ont été acceptées avec effet immédiat;

- Les personnes suivantes ont été nommées, avec effet immédiat et ce jusqu'à l'assemblée générale qui statuera sur

les comptes clos au 31 décembre 2017:

* (i) Madame Sandrine BISARO, née le 28 juin 1969 à Metz, France, résidant professionnellement au 16, avenue Pasteur,

L-2310 Luxembourg, en tant qu'administrateur de la Société;

* (ii) Madame Christelle MATHIEU, née le 1 

er

 mars 1978 à Virton, Belgique, résidant professionnellement au 16,

avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, en tant qu'administrateur de la Société;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juillet 2014.

Référence de publication: 2014117268/19.
(140135328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2014.

126202

L

U X E M B O U R G

School 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1-3, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 129.563.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014107921/9.
(140128747) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2014.

SciCan Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 15.150,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 123.890.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juillet 2014.

Référence de publication: 2014107924/10.
(140128522) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2014.

Sigla Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 9.699.775,00.

Siège social: L-1445 Strassen, 1A, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 105.982.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 juillet 2014.

Référence de publication: 2014107927/10.
(140129006) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2014.

Grel S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 178.942.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de l'actionnaire unique tenue extraordinairement le 27 juin 2014 au

<i>siège social

L'assemblée générale décide de réélire les administrateurs pour un nouveau mandat expirant à l'assemblée générale

annuelle statuant sur les comptes 2014 comme suit:

<i>Conseil d'Administration:

- Monsieur Fabio MORVILLI, né le 17 septembre 1956 à Rome (Italie) demeurant au 12, rue du château, L-7463 Pettigen,

Luxembourg, administrateur;

- Monsieur Giovanni CARONIA, né le 5 mai 1940 à Palerme (Italie), demeurant au 5, via Gran San Bernardo I-20154

Milan Italie, administrateur;

- Monsieur Federico FRANZINA, né le 1 

er

 Avril 1961 à Padova (Italie), demeurant professionnellement au 5, Place

du Théâtre, L-2613 Luxembourg, administrateur.

L'assemblée générale décide de nommer en tant que nouvelle personne chargée du contrôle des comptes, pour un

mandat expirant à l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes 2014, le commissaire aux comptes suivant:

- VALIANNA S.A., ayant son siège social au 34, rue Scheuerberg, L-5422 Erpeldange (Luxembourg), RCS Luxembourg

B 85.192, commissaire aux comptes.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 juillet 2014.

<i>Pour la Société

Référence de publication: 2014117304/25.
(140135576) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2014.

126203

L

U X E M B O U R G

MALG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 151.445.

Les comptes annuels au 31 août 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014109719/9.
(140131208) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2014.

Muzinich European Private Debt Fund, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV

- Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 176.286.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juillet 2014.

Référence de publication: 2014109715/11.
(140131544) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2014.

MENA Joint Investment Fund S.C.A., SICAV-SIF, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une

SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 153.372.

Les comptes consolidés de la Société au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 juillet 2014.

Malcolm Wilson
<i>Mandataire

Référence de publication: 2014109731/14.
(140130859) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2014.

Sagra Holdings, Société Anonyme.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 180.656.

Il résulte des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire de la Société en date du 25 juillet 2014 que:
- Monsieur Mario Cohn, ayant son adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg démis-

sionne de son poste d'administrateur B de la société avec effet au 25 juillet 2014;

- Monsieur Giovanni La Forgia, ayant son adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg

démissionne de son poste d'administrateur B de la société avec effet au 25 juillet 2014;

- Monsieur Johannes Andries van den Berg, né le 28 décembre 1979 à Pijnacker, Pays-Bas, et ayant son adresse pro-

fessionnelle au 124, Boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg est nommé en remplacement de l'administrateur B
démissionnaire avec effet au 25 juillet 2014 et ce pour une durée de 6 ans;

- Madame Corinne Shim Sophie Muller, née le 15 octobre 1976 à Seoul, Corée du Sud, et ayant son adresse profes-

sionnelle  au  124,  Boulevard  de  la  Pétrusse,  L-2330  Luxembourg  est  nommé  en  remplacement  de  l'administrateur  B
démissionnaire avec effet au 25 juillet 2014 et ce pour une durée de 6 ans.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 25 juillet 2014.

Référence de publication: 2014110945/20.
(140132148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2014.

126204

L

U X E M B O U R G

Algohal S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 148.101.

Les comptes annuels, les comptes de Profits et Pertes ainsi que les Annexes de l'exercice clôturant au 31/12/2013 ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>L'Organe de Gestion

Référence de publication: 2014110197/11.
(140132354) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2014.

Alison Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 4, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 76.756.

Référence est faite à l'extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration en date du 26 Mars 2014 déposé

le  6  Mai  2014  sous  la  référence  L140072783  et  publié  le  8  juillet  2014  au  Mémorial  C  n°  1766  sous  la  référence
2014062459/13.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 17 juin 2014

- la cooptation de Monsieur BECKER, né le 10 janvier 1950 à Metz (France), et demeurant au 66, rue de Queuleu,

F-57070 METZ, est ratifiée.

Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2017.

Certifié sincère et conforme

Référence de publication: 2014110198/15.
(140132269) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2014.

Alma Consultancy S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 95.407.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 13 juin 2014

Il résulte du procès-verbal que:
- Madame la Présidente donne lecture à l'Assemblée des actionnaires des lettres de démission des administrateurs

suivants:

1. CARDALE OVERSEAS INC.;
2. TASWELL INVESTMENTS LTD;
3. KELWOOD INVESTMENTS LIMITED;
- L'assemblée Générale accepte les démissions de CARDALE OVERSEAS INC., TASWELL INVESTMENTS LTD, KEL-

WOOD INVESTMENTS LIMITED de leurs mandats d'Administrateurs.

- L'assemblée Générale décide de nommer les administrateurs suivants au lieu et place des administrateurs sortants,

à savoir:

1. Monsieur Antonio SAINZ demeurant professionnellement au 7 rue Fénelon 33000 Bordeaux, administrateur délégué

à la gestion journalière;

2. Madame Marie-Hélène PAYET demeurant professionnellement au 7 rue Fénelon 33000 Bordeaux;
3. Madame Carolina Aranguren Pecino demeurant professionnellement au rue Fénelon 33000 Bordeaux;
- La durée de ces mandats sera jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2019.
- L'Assemblée renouvelle  le mandat  de  la  société  BENOY  KARTHEISER  MANAGEMENT  S.à  r.l., inscrite sous  le

numéro B 33 849 et ayant son siège social 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg en tant que commissaire aux comptes
jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2019.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

ALMA CONSULTANCY S.A.

Référence de publication: 2014110203/28.
(140131989) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2014.

126205

L

U X E M B O U R G

Quinta Greentech Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 1.638.451,00.

Siège social: L-1430 Luxembourg, 6, boulevard Pierre Dupong.

R.C.S. Luxembourg B 187.410.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-seventh day of June,
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

was held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Quinta Greentech Investments S.à r.l., a

private limited liability company (société à responsabilité limitée) organized under the laws of the Grand Duchy of Lu-
xembourg,  having  its  registered  office  at  6,  Boulevard  Pierre  Dupong,  L-1430  Luxembourg,  in  the  process  of  being
registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies (R.C.S. Luxembourg) and having a share capital
of twenty-four thousand four hundred and one United States Dollars (USD 24,401.-) (the Company). The Company has
been incorporated on May 22, 2014 pursuant to a deed of the undersigned notary, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations of June 10, 2014 number 1481. The articles of association of the Company have not been
amended since the date of its incorporation.

There appeared

Quinta Greentech Holding Limited, a limited company governed by the laws of the British Virgin Islands, having its

registered office at Trident Trust Company (BVI) Limited, Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British
Virgin Islands, registered with the Register of Commerce and Companies of Tortola, British Virgin Islands under number
1811982 (the Sole Shareholder),

here represented by Régis Galiotto, notary clerk, with professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-

bourg, by virtue of a proxy given under private seal on June 24, 2014.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned

notary, shall remain attached to this notarial deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, represented as described above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. That the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company;
II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Increase of the share capital of the Company by an amount of one million six hundred fourteen thousand fifty United

States Dollars (USD 1,614,050.-), in order to bring the share capital of the Company from its present amount of twenty-
four  thousand  four  hundred  and  one  United  States  Dollars  (USD  24,401.-),  represented  by  eighteen  thousand  two
(18,002) ordinary shares, seven hundred eleven (711) class A shares, seven hundred eleven (711) class B shares, seven
hundred eleven (711) class C shares, seven hundred eleven (711) class D shares, seven hundred eleven (711) class E
shares, seven hundred eleven (711) class F shares, seven hundred eleven (711) class G shares, seven hundred eleven (711)
class H shares and seven hundred eleven (711) class I shares, each share of each class of shares having a par value of one
United States Dollar (USD 1.-) to one million six hundred thirty-eight thousand five hundred fifty-one United States
Dollars (USD 1,638,451.-), by way of the issue of eight (8) ordinary shares, one hundred seventy-nine thousand three
hundred thirty-eight (179,338) class A shares, one hundred seventy-nine thousand three hundred thirty-eight (179,338)
class B shares, one hundred seventy-nine thousand three hundred thirty-eight (179,338) class C shares, one hundred
seventy-nine thousand three hundred thirty-eight (179,338) class D shares, one hundred seventy-nine thousand three
hundred thirty-eight (179,338) class E shares, one hundred seventy-nine thousand three hundred thirty-eight (179,338)
class F shares, one hundred seventy-nine thousand three hundred thirty-eight (179,338) class G shares, one hundred
seventy-nine thousand three hundred thirty-eight (179,338) class H shares and one hundred seventy-nine thousand three
hundred thirty-eight (179,338) class I shares, each share of each class of shares having a par value of one United States
Dollar (USD 1.-) to as well as the same rights and obligations as the existing classes of shares.

2. Subscription to and payment of the increase of the share capital as described in item 1. above by a payment in cash.

3. Subsequent amendment to the first (1 

st

 ) paragraph of article six (6) of the articles of association of the Company

(the Articles) in order to reflect the increase of the share capital adopted under item 1. above.

4. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and

authority given to any manager of the Company (each an Authorized Representative), each individually, to proceed in the
name and on behalf of the Company with the registration of the newly issued shares in the register of shareholders of
the Company.

5. Miscellaneous.
III. That the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

126206

L

U X E M B O U R G

<i>First Resolution:

The Sole Shareholder resolves to increase and hereby increases the share capital of the Company by an amount of

one million six hundred fourteen thousand fifty United States Dollars (USD 1,614,050.-), in order to bring the share capital
of the Company from its present amount of twenty-four thousand four hundred and one United States Dollars (USD
24,401.-), represented by eighteen thousand two (18,002) ordinary shares, seven hundred eleven (711) class A shares,
seven hundred eleven (711) class B shares, seven hundred eleven (711) class C shares, seven hundred eleven (711) class
D shares, seven hundred eleven (711) class E shares, seven hundred eleven (711) class F shares, seven hundred eleven
(711) class G shares, seven hundred eleven (711) class H shares and seven hundred eleven (711) class I shares, each share
of each class of shares having a par value of one United States Dollar (USD 1.-) to one million six hundred thirty-eight
thousand five hundred fifty-one United States Dollars (USD 1,638,451.-), by way of the issue of eight (8) ordinary shares,
one hundred seventy-nine thousand three hundred thirty-eight (179,338) class A shares, one hundred seventy-nine thou-
sand three hundred thirty-eight (179,338) class B shares, one hundred seventy-nine thousand three hundred thirty-eight
(179,338) class C shares, one hundred seventy-nine thousand three hundred thirty-eight (179,338) class D shares, one
hundred seventy-nine thousand three hundred thirty-eight (179,338)) class E shares, one hundred seventy-nine thousand
three  hundred  thirty-eight  (179,338)  class  F  shares,  one  hundred  seventy-nine  thousand  three  hundred  thirty-eight
(179,338) class G shares, one hundred seventy-nine thousand three hundred thirty-eight (179,338) class H shares and
one hundred seventy-nine thousand three hundred thirty-eight (179,338) class I shares, each share of each class of shares
having a par value of one United States Dollar (USD 1.-) as well as the same rights and obligations as the existing Shares.

<i>Second Resolution:

The Sole Shareholder resolves to accept and record the following subscription to and full payment of the capital

increase as follows:

<i>Subscription - Payment

The Sole Shareholder hereby declares that it subscribes to eight (8) ordinary shares, one hundred seventy-nine thou-

sand three hundred thirty-eight (179,338) class A shares, one hundred seventy-nine thousand three hundred thirty-eight
(179,338) class B shares, one hundred seventy-nine thousand three hundred thirty-eight (179,338) class C shares, one
hundred seventy-nine thousand three hundred thirty-eight (179,338) class D shares, one hundred seventy-nine thousand
three  hundred  thirty-eight  (179,338)  class  E  shares,  one  hundred  seventy-nine  thousand  three  hundred  thirty-eight
(179,338) class F shares, one hundred seventy-nine thousand three hundred thirty-eight (179,338) class G shares, one
hundred seventy-nine thousand three hundred thirty-eight (179,338) class H shares and one hundred seventy-nine thou-
sand three hundred thirty-eight (179,338) class I sharesof the Company and fully pays up such shares by a payment in
cash in an amount of one million six hundred fourteen thousand fifty United States Dollars (USD 1,614,050.-) which is
evidenced to the notary by a blocking certificate (certificat de blocage) and which shall be allocated to the nominal share
capital account of the Company.

The amount of the increase of the share capital is forthwith at the free disposal of the Company, evidence of which

has been given to the undersigned notary.

<i>Third resolution:

As a consequence of the foregoing resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend the first (1 

st

 ) paragraph of

article six (6) of the Articles in order to reflect the above changes which shall henceforth read as follows:

“ Art. 6. Share capital. (first paragraph). The subscribed share capital of the Company is set at one million six hundred

thirty-eight thousand five hundred fifty-one United States Dollars (USD 1,638,451.-), represented by eighteen thousand
ten (18,010) Ordinary Shares, one hundred eighty thousand forty-nine (180,049) Class A Shares, one hundred eighty
thousand forty-nine (180,049) Class B Shares, one hundred eighty thousand forty-nine (180,049) Class C Shares, one
hundred eighty thousand forty-nine (180,049) Class D Shares, one hundred eighty thousand fourty-nine (180,049) Class
E Shares, one hundred eighty thousand forty-nine (180,049) Class F Shares, one hundred eighty thousand forty-nine
(180,049) Class G Shares, one hundred eighty thousand forty-nine (180,049) Class H Shares and one hundred eighty
thousand forty-nine (180,049) Class I Shares, each Share of each class of shares having a par value of one United States
Dollar (USD 1.-).”

<i>Fourth Resolution:

The Sole Shareholder resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above

changes and empowers and authorizes any Authorized Representative, each individually, to proceed in the name and on
behalf of the Company with the registration of the newly issued ordinary shares, class A shares, class B shares, class C
shares, class D shares, class E shares, class F shares, class G shares, class H shares and class I shares in the register of
shareholders of the Company.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately two thousand six hundred Euros (2,600.- EUR).

126207

L

U X E M B O U R G

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the proxyholder

of the above appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the
same proxyholder of the appearing party and in case of divergences between the English and the French versions, the
English version will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
This document having been read to the proxyholder of the appearing party, who is known to the undersigned notary

by his/her surname, name, civil status and residence, the said proxyholder of the appearing party signed the present deed
together with the undersigned notary.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le vingt-septième du mois de juin,
Pardevant nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est tenue

une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de Quinta Greentech Investments S.à r.l., une

société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 6,
Boulevard Pierre Dupong, L-1430 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en cours d'immatriculation au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (R.C.S. Luxembourg) et ayant un capital social de vingt-quatre mille quatre
cent et un dollars des Etats-Unis (USD 24.401,-) (la Société). La Société a été constituée le 22 mai 2014 suivant un acte
du notaire soussigné, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 10 juin 2014 sous le numéro 1481.
Les statuts de la Société n'ont pas été modifiés depuis la date de sa constitution.

A comparu

Quinta Greentech Holding Limited, une société, régie par les lois de Îles Vierges Britanniques, ayant son siège social

à Trident Trust Company (BVI) Limited, Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, Îles Vierges Britanniques,
immatriculée au Registre de Commerce et Sociétés de Tortola, Îles Vierges Britanniques (l'Associé Unique),

ici représentée par Régis Galiotto, clerc de notaire, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, Grand-Duché

de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 24 juin 2014.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante ainsi que par le notaire

soussigné, restera annexée au présent acte notarié pour être soumise ensemble aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante, représentée tel que décrit ci-dessus, a requis le notaire soussigné d'acter ce qui suit:
I. Que l'Associé Unique détient toutes les parts sociales dans le capital social de la Société;
II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant d'un million six cent quatorze mille cinquante dollars des

Etats-Unis (USD 1.614.050,-), dans le but de porter le capital social de la Société de son montant actuel de vingt-quatre
mille quatre cent et un dollars des Etats-Unis (USD 24.401,-), représenté par dix-huit mille deux (18.002) parts sociales
ordinaires, sept cent onze (711) parts sociales de catégorie A, sept cent onze (711) parts sociales de catégorie B, sept
cent onze (711) parts sociales de catégorie C, sept cent onze (711) parts sociales de catégorie D, sept cent onze (711)
parts sociales de catégorie E, sept cent onze (711) parts sociales de catégorie F, sept cent onze (711) parts sociales de
catégorie G, sept cent onze (711) parts sociales de catégorie H et sept cent onze (711) parts sociales de catégorie I,
chaque part sociale de chaque catégorie de parts sociales ayant une valeur nominale d'un dollar des Etats-Unis (USD 1,-)
à un million six cent trente-huit mille quatre cent cinquante et un dollars des Etats-Unis (USD 1.638,451,-) par l'émission
de huit (8) parts sociales ordinaires, cent soixante-dix-neuf mille trois cent trente-huit (179.338) parts sociales de catégorie
A, cent soixante-dix-neuf mille trois cent trente-huit (179.338) parts sociales de catégorie B, cent soixante-dix-neuf mille
trois cent trente-huit (179.338) parts sociales de catégorie C, cent soixante-dix-neuf mille trois cent trente-huit (179.338)
parts sociales de catégorie D, cent soixante-dix-neuf mille trois cent trente-huit (179.338) parts sociales de catégorie E,
cent soixante-dix-neuf mille trois cent trente-huit (179.338) parts sociales de catégorie F, cent soixante-dix-neuf mille
trois cent trente-huit (179.338) parts sociales de catégorie G, cent soixante-dix-neuf mille trois cent trente-huit (179.338)
parts sociales de catégorie H et cent soixante-dix-neuf mille trois cent trente-huit (179.338) parts sociales de catégorie
I, chaque part sociale de chacune des catégories de parts sociales ayant une valeur nominale de un dollar des Etats-Unis
(USD 1,-) ainsi que les mêmes droits et obligations que ceux attachés aux catégories de parts sociales existantes.

2. Souscription à et libération de l'augmentation du capital social tel que décrit au point 1. ci-dessus par un paiement

en numéraire.

3. Modification subséquente du premier (1 

er

 ) paragraphe de l'article six (6) des statuts de la Société (les Statuts) afin

de refléter l'augmentation du capital social adoptée au point 1. ci-dessus.

4. Modification du registre des associés de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité

donnée à tout gérant de la Société (chacun un Représentant Autorisé), chacun individuellement, pour procéder au nom
et pour le compte de la Société à l'enregistrement des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés
de la Société.

5. Divers.

126208

L

U X E M B O U R G

III. Que l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution:

L'Associé Unique décide d'augmenter et par la présente augmente le capital social de la Société d'un montant d'un

million six cent quatorze mille cinquante dollars des Etats-Unis (USD 1.614.050,-), dans le but de porter le capital social
de la Société de son montant actuel de vingt-quatre mille quatre cent et un dollars des Etats-Unis (USD 24.401,-), re-
présenté par dix-huit mille deux (18.002) parts sociales ordinaires, sept cent onze (711) parts sociales de catégorie A,
sept cent onze (711) parts sociales de catégorie B, sept cent onze (711) parts sociales de catégorie C, sept cent onze
(711) parts sociales de catégorie D, sept cent onze (711) parts sociales de catégorie E, sept cent onze (711) parts sociales
de catégorie F, sept cent onze (711) parts sociales de catégorie G, sept cent onze (711) parts sociales de catégorie H et
sept cent onze (711) parts sociales de catégorie I, chaque part sociale de chaque classe de parts sociales ayant une valeur
nominale d'un dollar des Etats-Unis (USD 1,-) à un million six cent trente-huit mille quatre cent cinquante et un dollars
des Etats-Unis (USD 1.638,451,-) par l'émission de huit (8) parts sociales ordinaires, cent soixante-dix-neuf mille trois
cent trente-huit (179.338) parts sociales de catégorie A, cent soixante-dix-neuf mille trois cent trente-huit (179.338) parts
sociales de catégorie B, cent soixante-dix-neuf mille trois cent trente-huit (179.338) parts sociales de catégorie C, cent
soixante-dix-neuf mille trois cent trente-huit (179.338) parts sociales de catégorie D, cent soixante-dix-neuf mille trois
cent trente-huit (179.338) parts sociales de catégorie E, cent soixante-dix-neuf mille trois cent trente-huit (179.338) parts
sociales de catégorie F, cent soixante-dix-neuf mille trois cent trente-huit (179.338) parts sociales de catégorie G, cent
soixante-dix-neuf mille trois cent trente-huit (179.338) parts sociales de catégorie H et cent soixante-dix-neuf mille trois
cent trente-huit (179.338) parts sociales de catégorie I, chaque part sociale de chacune des catégories de parts sociales
ayant une valeur nominale d'un dollar des Etats-Unis (USD 1,-) ainsi que les mêmes droits et obligations que ceux attachés
aux parts sociales existantes.

<i>Deuxième résolution:

L'Associé Unique décide d'accepter et d'enregistrer la souscription suivante ainsi que la libération intégrale de l'aug-

mentation du capital comme suit:

<i>Souscription - Libération

L'Associé Unique déclare qu'il souscrit à huit (8) sociales ordinaires, cent soixante-dix-neuf mille trois cent trente-huit

(179.338) parts sociales de catégorie A, cent soixante-dix-neuf mille trois cent trente-huit (179.338) parts sociales de
catégorie B, cent soixante-dix-neuf mille trois cent trente-huit (179.338) parts sociales de catégorie C, cent soixante-dix-
neuf mille trois cent trente-huit (179.338) parts sociales de catégorie D, cent soixante-dix-neuf mille trois cent trente-
huit (179.338) parts sociales de catégorie E, cent soixante-dix-neuf mille trois cent trente-huit (179.338) parts sociales
de catégorie F, cent soixante-dix-neuf mille trois cent trente-huit (179.338) parts sociales de catégorie G, cent soixante-
dix-neuf mille trois cent trente-huit (179.338) parts sociales de catégorie H et cent soixante-dix-neuf mille trois cent
trente-huit (179.338) parts sociales de catégorie I de la Société et libère entièrement lesdites parts sociales par un paie-
ment en numéraire d'un montant d'un million six cent quatorze mille cinquante dollars des Etats-Unis (USD 1.614.050,-)
documenté au notaire par un certificat de blocage et qui sera affecté au compte capital social nominal de la Société.

Le montant de l'augmentation du capital social est désormais à la libre disposition de la Société dont la preuve a été

apportée au notaire soussigné.

<i>Troisième Résolution:

En conséquence des résolutions qui précèdent, l'Associé Unique décide de modifier le premier (1 

er

 ) paragraphe de

l'article six (6) des Statuts afin de refléter les modifications ci-dessus et décide que cet article aura désormais la teneur
suivante:

« Art. 6. Capital Social. Le capital social souscrit de la Société est fixé à un million six cent trente-huit mille quatre cent

cinquante et un dollars des Etats-Unis (USD 1.638.451,-), représenté par dix huit mille dix (18.010) Parts Sociales Ordi-
naires, cent quatre-vingt mille quarante-neuf (180.049) Parts Sociales de Catégorie A, cent quatre-vingt mille quarante-
neuf (180.049) Parts Sociales de Catégorie B, cent quatre-vingt mille quarante-neuf (180.049) Parts Sociales de Catégorie
C, cent quatre-vingt mille quarante-neuf (180.049) Parts Sociales de Catégorie D, cent quatre-vingt mille quarante-neuf
(180.049) Parts Sociales de Catégorie E, cent quatre-vingt mille quarante-neuf (180.049) Parts Sociales de Catégorie F,
cent quatre-vingt mille quarante-neuf (180.049) Parts Sociales de Catégorie G, cent quatre-vingt mille quarante-neuf
(180.049) Parts Sociales de Catégorie H et cent quatre-vingt mille quarante-neuf (180.049) Parts Sociales de Catégorie I
de la Société, chaque Part Sociale de chacune des catégories de parts sociales ayant une valeur nominale de un Dollar
américain (USD 1,-).»

<i>Quatrième Résolution:

L'Associé Unique décide de modifier le registre des associés de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus

et donne pouvoir et autorité à tout Représentant Autorisé, chacun individuellement, pour procéder au nom et pour le
compte de la Société à l'enregistrement des parts sociales ordinaires, parts sociales de catégorie A, parts sociales de
catégorie B, parts sociales de catégorie C, parts sociales de catégorie D, parts sociales de catégorie E, parts sociales de

126209

L

U X E M B O U R G

catégorie F, parts sociales de catégorie G, parts sociales de catégorie H et parts sociales de catégorie I nouvellement
émises dans le registre des associés de la Société.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

en raison du présent acte, sont estimés approximativement à la somme de deux mille six cents Euros (2.600.- EUR).

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête du mandataire de la partie comparante,

le présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de ce même mandataire de la partie
comparante et en cas de divergence entre les versions anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé, même date qu'en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, connu du notaire soussigné par son nom, prénom usuel,

état civil et demeure, ledit mandataire de la partie comparante a signé avec le notaire soussigné le présent acte.

Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 4 juillet 2014. Relation: LAC/2014/31206. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur

 (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 23 juillet 2014.

Référence de publication: 2014109872/242.
(140131297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2014.

High Gate Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 166.217.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty first day of July.
Before Us, Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg,

There appeared

Blue Crest Holding S.A. a public limited liability company (société anonyme) having its registered office at 19, rue

Eugene Ruppert, L-2453 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B
166.218 holder of two million four hundred and sixty thousand nine hundred thirty five (2,460,935) shares (the “Sole
Shareholder”),

represented by Ms. Claudia Rouckert, employee, residing professionally at Esch-sur-Alzette, by virtue of proxy given

under private seal.

The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and

the undersigned notary.

Such appearing party, acting in the here above stated capacity, requested the undersigned notary to state that:
Blue Crest Holding S.A. is the Sole Shareholder of "High Gate Holding S.A.", a public limited liability company (société

anonyme), existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office 19, rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 166.217, consti-
tuted by a deed of Me Henri Beck, notary residing in Echternach, Grand-Duchy of Luxembourg, on December 29, 2011,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 522 on February 28, 2012.

The articles of association of the Company have been amended several times and for the last time by a deed of Me

Francis Kesseler notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg, on February 8, 2013, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°1213 on March 25, 2013 (the “Company”).

The Sole Shareholder declared and requested the notary to record the following:

<i>First resolution

The Sole shareholder RESOLVES to approve the interim financial statements of the Company for the period from

January 2014 to the date of the present resolutions.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder RESOLVES to grant discharge to the members of the board of directors of the Company with

respect to the performance of their duties for the period from 1 

st

 January 2014 to the date hereof.

<i>Third resolution

In compliance with the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended from time to time (the “Law”),

the Sole Shareholder RESOLVES to dissolve the Company and to put into liquidation.

126210

L

U X E M B O U R G

<i>Fourth resolution

The Sole Shareholder RESOLVES to appoint as liquidator (“liquidateur”) of the Company:
- Sigma Enterprise One INC., a company governed by the laws of British Virgin Islands, having its registered office

OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands with the BVI registration number 1828159
(the “Liquidator”).

The aforesaid Liquidator has to realise all of the assets and liabilities of the Company. The Liquidator is exempted from

the obligation of drawing up an inventory, and may in this respect rely fully on the books of the Company, especially the
interim financial statements drawn up as at the date of the present resolutions.

The Liquidator may under its own responsibility and regarding special or specific transactions, delegate such part of

its powers as it may deem fit, to one or several representatives.

The Liquidator binds validly and without limitation the Company in the process of being liquidated.
The Liquidator has the authority to perform and execute all transactions provided for in Articles 144 and 145 of the

Law, without specific authorisation therefore from the general shareholder's meeting.

The Liquidator may make advances on the liquidation surplus in cash or kind and in particular consisting of the shares

the Company holds in its subsidiaries which the sole shareholder hereby specifically accepts after having paid the debts
or made the necessary provisions for the payment of the debts or it may transfer all assets and liabilities of the Company
to its sole shareholder upon commitment of the latter to pay any debts incurred presently or in the future.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded

in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, who signed together with the undersigned

notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le vingt-et-un juillet,
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique (l'«Assemblée Générale») de la société anonyme existant

sous la dénomination sociale «High Gate Holding S.A.» une société anonyme valablement existante sous les lois du Grand-
Duché de Luxembourg ayant son siège social au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, immatriculée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 166.217, constituée suivant un acte reçu par
Maître Henri Beck, notaire résidant à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, daté du 29 décembre 2011, publié au
Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 522 du 28 Février 2012.

Les statuts de la Société ont été modifies à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant un acte reçu par Maître

Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, le 8 février 2013, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1213 du 25 mars 2013.

L'Associé Unique déclare et requiert le notaire instrumentant d'acter que:

<i>Première résolution

L'Associé Unique DECIDE d'approuver les états financiers intérimaires de la Société du 1 

er

 janvier 2014 jusqu'au jour

des présentes résolutions.

<i>Seconde résolution

L'Associé Unique DECIDE d'accorder décharge aux membres du conseil d'administration de la Société pour l'accom-

plissement de leurs mandats pour la période allant du 1 

er

 janvier 2014 jusqu'à ce jour.

<i>Troisième résolution

Conformément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée (la «Loi»), l'Associé Unique

DECIDE de dissoudre la Société et de procéder à sa mise en liquidation volontaire.

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée Générale DECIDE de nommer en tant que liquidateur de la Société:
Sigma Enterprise One INC., une société régie par les lois des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social au OMC

Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques immatriculée sous le BVI numéro 1828159
(le «Liquidateur»).

126211

L

U X E M B O U R G

Le Liquidateur prénommé a la mission de réaliser tout l'actif et d'apurer le passif de la Société. Le Liquidateur est

dispensé de l'obligation de dresser un inventaire et peut à ce titre se référer pleinement aux écritures de la Société sur
la comptabilité de la Société, en particulier les états financiers intérimaires au jour des présentes résolutions.

Le Liquidateur pourra sous sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer tout ou

partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires.

Le Liquidateur peut engager valablement et sans limitation la Société en cours de liquidation.
Le Liquidateur dispose du pouvoir pour toutes les opérations prévus aux Articles 144 et 145 de la Loi, sans avoir

besoin d'être préalablement autorisé par l'assemblée générale de l'associé.

Le Liquidateur peut faire des avances sur le boni de liquidation en numéraire ou en nature et particulièrement consistant

en actions détenues par les filiales de la Société, après avoir payé les dettes ou avoir fait les provisions nécessaires pour
le paiement des dettes ou il peut transférer tout l'actif et le passif de la Société à son associé unique sur accord de ce
dernier de payer toutes les dettes actuelles encourues ou futures.

Le notaire instrumentant qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande de la partie comparante, le présent

acte est écrit en anglais, suivi d'une version en langue française. A la demande de la même partie comparante, il est déclaré
qu'en cas de désaccord entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra.

DONT ACTE notarié, dressé et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.
Lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé l'original du présent acte avec le notaire

instrumentant.

Signé: Rouckert, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 23 juillet 2014. Relation: EAC/2014/10284. Reçu douze euros 12,00 €.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2014110510/110.
(140132737) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2014.

Signode Industrial Group Holdings Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 100.010,00.

Siège social: L-8010 Strassen, 148, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 185.643.

In the year two thousand and fourteen, on the sixteenth day of July, before Maître Francis Kesseler, notary residing

in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,

was held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Signode Industrial Group Holdings Lux S.à

r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and organized under the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 6, Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 185.643 and having
a share capital amounting to USD 100,010.- (the Company). The Company has been incorporated on March 12, 2014
pursuant to a deed of Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, N° - 1401 of May 31, 2014. The articles of association (the Articles) have not been amended
since the incorporation.

There appeared:

Vault Bermuda Holding Co. Ltd., an exempted company incorporated under the laws of Bermuda, having its registered

office at Clarendon House 2 Church Street, Hamilton HM 11 Bermuda, registered with the Bermuda Registrar of Com-
panies under number 48705 (the Sole Shareholder);

hereby represented by Ms. Claudia Rouckert, employee, whose professional address is in Esch-sur-Alzette, Grand

Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal,

which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following:
I. That the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company.
II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Transfer of the registered office of the Company from its current address to 148, route d'Arlon, L-8010 Strassen,

Grand Duchy of Luxembourg;

2. Subsequent amendment of article 2.1 of the articles of association of the Company; and
3. Miscellaneous.

126212

L

U X E M B O U R G

III. That the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to transfer the registered office of the Company from its current address to 148, route

d'Arlon, L-8010 Strassen, Grand Duchy of Luxembourg, effective as of the date hereof.

<i>Second resolution

As a result of the above resolution, the Sole Shareholder resolves to amend article 2.1 of the Articles, which shall

henceforth read as follows:

“ 2.1. The registered office of the Company is established in Strassen, Grand Duchy of Luxembourg. It may be trans-

ferred within the municipality by a resolution of the board of managers. The registered office may be transferred to any
other  place  in  the  Grand  Duchy  of  Luxembourg  by  a  resolution  of  the  shareholders,  acting  in  accordance  with  the
conditions prescribed for the amendment of the Articles.”

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, the proxy holder of the appearing party

signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le seizième jour de juillet, par devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-

sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est tenue

une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de Signode Industrial Group Holdings Lux S.à

r.l., une société à responsabilité limitée constituée et organisée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son
siège  social  au  6,  Eugène  Ruppert,  L-2453  Luxembourg,  Grand-Duché  de  Luxembourg,  immatriculée  au  Registre  de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 185.643 et disposant d'un capital social d'un montant de
USD 100.010,- (la Société). La Société a été constituée le 12 mars 2014 suivant un acte de Maître Francis Kesseler, notaire
de résidence à Esch-sur-Alzette, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° - 1401 du 31 mai 2014.
Les statuts de la Société (les Statuts) n'ont pas été modifiés depuis la constitution.

A comparu:

Vault Bermuda Holding Co. Ltd., une société exemptée (exempted company) constituée en vertu des lois des Ber-

mudes, dont le siège social se situe à Clarendon House 2 Church Street, Hamilton HM 11 Bermudes, immatriculée au
Registre des Sociétés des Bermudes sous le numéro 48705 (l'Associé Unique);

ici représenté par Mlle. Claudia Rouckert, employée privée, de résidence professionnelle à Esch-sur-Alzette, Grand-

Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé,

laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie com-

parante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être soumise avec lui auprès des autorités
d'enregistrement.

L'Associé Unique a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Que l'Associé Unique détient toutes les parts sociales dans le capital social de la Société.
II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé de la manière suivante:
1. Transfert du siège social de la Société de son adresse actuelle au 148, route d'Arlon, L-8010 Strassen, Grand-Duché

de Luxembourg;

2. Modification subséquente de l'article 2.1 des statuts de la Société; et
3. Divers.
III. Que l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé Unique décide de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle au 148, route d'Arlon, L-8010

Strassen, Grand-Duché de Luxembourg avec effet à la date des présentes.

<i>Deuxième résolution

En  conséquence  de  la  résolution  ci-dessus,  l'Associé  Unique  décide  de  modifier  l'article  2.1  des  Statuts,  qui  aura

désormais la teneur suivante:

126213

L

U X E M B O U R G

2.1. Le siège social de la Société est établi à Strassen, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans cette

même commune par décision du conseil de gérance. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-
Duché de Luxembourg par une résolution des associés, agissant selon les modalités requises pour la modification des
Statuts."

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte

est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête de la même partie comparante, en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont Acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, à la date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé avec Nous, le

notaire, le présent acte original.

Signé: Rouckert, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 18 juillet 2014. Relation: EAC/2014/10053. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur

 (signé): A. Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2014110959/100.
(140132731) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2014.

Helpling Group Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 14.209,00.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 184.677.

In the year two thousand and fourteen, on the tenth day of July.
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

1. Rocket Internet AG (formerly Rocket Internet GmbH), a stock corporation (Aktiengesellschaft) existing under the

laws of Germany with its statutory seat in Berlin, Germany, registered with the commercial register (Handelsregister) at
the local court of Charlottenburg (Amtsgericht Charlottenburg), Germany, under no. HRB 159634 B, having its business
address at Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Germany,

being the holder of ten thousand (10,000) shares of the Company,
here represented by Ms Alix van der Wielen, maître en droit, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a

proxy, given in Berlin, Germany, on 8 July 2014;

2.  Bambino  53.  V  V  UG  (haftungsbeschränkt),  a  limited  liability  company  (Unternehmergesellschaft  (haftungsbes-

chränkt)) existing under the laws of Germany with its statutory seat in Berlin, Germany, registered with the commercial
register at the local court of Charlottenburg (Amtsgericht Charlottenburg), Germany, under number HRB 126893 B,
having its registered address at Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Germany,

being the holder of two thousand five hundred (2,500) shares of the Company,
here represented by Ms Alix van der Wielen, maître en droit, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a

proxy, given in Berlin, Germany, on 4 July 2014;

3. Netris B.V., a limited liability company (Besloten Vennootschap) under the laws of the Netherlands with its registered

office in Schiphol, the Netherlands, registered with the commercial register of the Dutch Trade Register, under no.
60628022, having its business address at Schiphol Boulevard 127, 1118BG Schiphol, the Netherlands (hereinafter “Eiffel”),
participating and voting only for purposes of agenda point 4 et seqq.,

becoming the holder of four hundred seventeen (417) series A shares of the Company,
here represented by Ms Alix van der Wielen, maître en droit, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a

proxy, given in Schiphol, the Netherlands, on 4 July 2014;

4. Aismare Lux Holdings S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the

Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 176.544,
having its registered office at 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, and having a
share capital of forty-three thousand euros (EUR 43,000) (hereinafter “Aismare”), participating and voting only for pur-
poses of agenda point 4 et seqq.,

becoming the holder of one thousand two hundred fifty (1,250) series A shares of the Company,
here represented by Ms Alix van der Wielen, maître en droit, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a

proxy, given in Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, on 3 July 2014;

5. JP Ventures UG (haftungsbeschränkt), a limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) existing

under the laws of Germany with its statuory seat in Wehingen, Germany, registered with the commercial register (Han-

126214

L

U X E M B O U R G

delsregister) at the local court of Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart), Germany, under no. HRB 733673 B, having its business
address at Gosheimerstraße 48, 78564 Wehingen, Germany (hereinafter “ES”, together with Eiffel and Aismare, the “New
Investors”), participating and voting only for purposes of agenda point 4 et seqq.,

becoming the holder of forty-two (42) series A shares of the Company,
here represented by Ms Alix van der Wielen, maître en droit, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a

proxy, given in New York, United States of America, on 7 July 2014.

The said proxies, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary will remain annexed

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The parties 1. and 2. (the “Existing Shareholders”) are all the shareholders of Helpling Group Holding S.à r.l. (the

“Company”), a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxem-
bourg, having its registered office at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with
the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 184.677 and incorporated pursuant to a deed of the
undersigned notary on 7 February 2014, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1074
dated 28 April 2014. The articles of association were amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned
notary on 10 June 2014, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The Existing Shareholders representing the entire share capital and having waived any notice requirement, the general

meeting of shareholders is regularly constituted and may validly deliberate on the following agenda whereby the New
Investors participate and vote for purpose of agenda point 4 et seqq. only:

<i>Agenda

1. Decision to create two (2) classes of shares in the share capital of the Company, so that the Company will hence

have two (2) classes of shares, represented by common shares (hereinafter “Common Shares”) and series A shares
(hereinafter “Series A Shares”) and to convert the existing twelve thousand five hundred (12,500) shares, with a nominal
value of one euro (EUR 1) each, into twelve thousand five hundred (12,500) Common Shares, with a nominal value of
one euro (EUR 1) each, without cancellation of shares.

2. Acceptance of (i) Netris B.V., a limited liability company (Besloten Vennootschap) under the laws of the Netherlands

with its registered office in Schiphol, the Netherlands, registered with the commercial register of the Dutch Trade Re-
gister, under no. 60628022, having its business address at Schiphol Boulevard 127, 1118BG Schiphol, the Netherlands,
(ii) Aismare Lux Holdings S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 176.544, having
its registered office at 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, and having a share
capital  of  forty-three  thousand  euros  (EUR  43,000),  and  (iii)  JP  Ventures  UG  (haftungsbeschränkt),  a  limited  liability
company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) existing under the laws of Germany with its statuory seat in Wehingen,
Germany, registered with the commercial register (Handelsregister) at the local court of Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart),
Germany, under no. HRB 733673 B, having its business address at Gosheimerstraße 48, 78564 Wehingen, Germany, as
new shareholders of the Company.

3. Increase of the Company’s share capital by an amount of one thousand seven hundred nine euro (EUR 1,709) so as

to raise it from its current amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) up to fourteen thousand two
hundred nine euro (EUR 14,209) by issuing one thousand seven hundred nine (1,709) Series A Shares with a nominal
value of one euro (EUR 1) each.

4. Subsequent amendment of article five point one (5.1) of the articles of association of the Company so that it shall

henceforth read as follows:

“ Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company’s share capital is set at fourteen thousand two hundred nine Euros (EUR 14,209.00), represented

by

5.1.1 twelve thousand five hundred (12,500) common shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each (he-

reinafter “Common Shares”), and

5.1.2 one thousand seven hundred nine (1,709) series A shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each

(hereinafter “Series A Shares”, the Series A Shares hereinafter also referred to as “Preferred Shares”).

The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by these

articles of association or by the Law.”

5. Full restatement of the articles of association of the Company so that they shall henceforth read as follows:

A. “Name - Purpose - Duration - Registered office

Art. 1. Name. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name Helpling Group

Holding S.à r.l. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial
companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.

126215

L

U X E M B O U R G

Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign

companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio.

2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it

holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the
Company.

2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by

issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.

2.4 The purpose of the Company is also (i) the acquisition by purchase, registration or in any other manner as well as

the transfer by sale, exchange or otherwise of intellectual and industrial property rights, (ii) the granting of license on
such intellectual and industrial property rights, and (iii) the holding and the management of intellectual and industrial
property rights.

2.5 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities

which it considers useful for the accomplishment of these purposes, in view of its realisation by sale, exchange or other-
wise.

Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Art. 4. Registered Office.
4.1 The registered office of the Company is established in the city of Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by decision of the board of managers. It

may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by resolution of the shareholders,
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution

of the board of managers.

4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances

or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
traordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwiths-
tanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

B. Share capital - Shares

Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company’s share capital is set at fourteen thousand two hundred nine Euros (EUR 14,209.00), represented

by

5.1.1 twelve thousand five hundred (12,500) common shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each (he-

reinafter “Common Shares”), and

5.1.2 one thousand seven hundred nine (1,709) series A shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each

(hereinafter “Series A Shares”, the Series A Shares hereinafter also referred to as “Preferred Shares”).

The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by these

articles of association or by the Law.

5.2 The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.3 Each of the shareholders Rocket Internet AG (“Rocket”), Netris B.V. (“Eiffel”), JP Ventures UG (haftungsbes-

chränkt) (“ES”) and/or Aismare Lux Holdings S.à r.l. (“Aismare”, jointly with Rocket, ES and Eiffel, the “Investors” and
each also an “Investor”) shall be entitled to subscribe for such amount of further shares to be issued in the course of a
capital increase implementing an investment offer of a third party (being neither a shareholder nor a company affiliated
to a shareholder within the meaning of sections 15 et seqq. German Stock Corporation Act (AktG) (a “Third Party
Investor”)  which  has  been  approved  with  a  majority  vote  of  at  least  seventy  five  per  cent  (75%)  of  the  votes  of  all
shareholders of the Company (such majority being a “Super Majority” and such investment being a “Third Party Invest-
ment”) - irrespective whether made by the Third Party Investor or one or more matching shareholders - required to
maintain up to its percentage ownership in the Company prior to such capital increase under the same terms and con-
ditions on which the Third Party Investment is based on. The respective Investor shall inform the Company by binding
declaration within three (3) weeks whether it intends to exercise its right pursuant to the foregoing sentence of this

126216

L

U X E M B O U R G

Article 5.3, following which the Third Party Investment (to the extent not taken up by the Investors under this Article
5.3) may proceed.

Art. 6. Shares.
6.1 The Company’s share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of

the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.

6.5 The Company may accept contributions without issuing shares or other securities in consideration and may allocate

such contributions to one or more distributable reserves. Decisions as to the use of any such distributable reserves are
to be taken by the shareholder(s) or the manager(s) as the case may be, subject to the Law and these articles of association.

Art. 7. Register of Shares - Transfer of Shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection

by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.

7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall

appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.

7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given

by a Super Majority and subject to the provisions of any shareholders’ agreement between the shareholders, if any, in
particular, any rights of first refusal, rights of pre-emption or tag-along rights or drag-along rights contained in any sha-
reholders’ agreement between the shareholders. To the extent that such approval has been granted, an additional consent
to the transfer of shares is not required:

7.4.1 in any case of a transfer, assignment or any other disposal of shares by any Investor to a company affiliated to

such Investor within the meaning of sections 15 et seqq. German Stock Corporation Act (AktG);

7.4.2 in case of a sale, transfer, assignment or any other disposal of shares by any Investor to a company (x) which is

directly or indirectly Controlling, Controlled by or under common Control with (i) this Investor or (ii) by one or more
direct or indirect shareholders of the respective Investor (each a “Controlled Company”), whereas “Control” or “Con-
trolled” or “Controlling” shall mean the direct or indirect domination of the company by way of (a) managing the company
as managing shareholder, (b) holding the majority of shares or (c) holding the majority of voting rights by means of a
contractual voting pool, or (d) the unilateral ability to cause, directly or indirectly, the direction of the management and
policies of a person, whether through the ownership of voting securities or otherwise, or (y) in which the respective
Investor or one or more shareholders of such Investor has a direct or indirect majority shareholding;

7.4.3 in case of a transfer, assignment or any other disposal of shares (i) to a party acquiring shares under the simplified

employee participation or (ii) to the Company and/or any Investor pursuant to a call-option under a vesting scheme;

7.4.4 in case of any transfer, assignment or any other disposal of shares within the framework of transformation

procedures pursuant to the transformation law of Luxembourg, in particular (but without limitation) a merger of the
Company, if the shareholders of the Company hold more than fifty per cent (50%) in any surviving legal entity after such
transformation procedure.

7.5 In the cases provided for in Articles 7.4.1 through 7.4.4 above, no duties to offer for sale apply, nor do any rights

of first refusal, rights of preemption or tag-along rights or drag-along rights in favour of other shareholders apply.

7.6 Any transfer, assignment or any other disposal of shares shall become effective towards the Company and third

parties through the notification of the transfer, assignment or any other disposal to, or upon the acceptance of the transfer,
assignment or any other disposal by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

7.7 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject

to the approval of such transfer given by a Super Majority (which, for these purposes, shall exclude the shares of the
deceased shareholder). Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents,
descendants or the surviving spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.

Art. 8. Liquidation and Sale Preferences.
8.1 In case (i) of any sale of at least fifty per cent (50%) of all shares in the Company, or a swap or a take-over of the

Company in an economically comparable way in a single or more related transactions or in close time proximity to one
another, or (ii) of the liquidation of the Company or (iii) of any sale or transfer of shares in the Company either to third
parties or other shareholders that would result in either more than fifty per cent (50%) of the registered share capital
or more than fifty per cent (50%) of the voting rights being owned by the acquiring party/parties (change of control) as
a result of one or more related acquisitions (each of the events described in (i), (ii) and (iii) is hereinafter referred to as
a “Liquidity Event”), the proceeds (“Exit Proceeds”) - subject to Article 8.2 below - will be distributed in accordance with

126217

L

U X E M B O U R G

Article 8.3 to the shareholders pro rata to (i) in case of an asset transfer, their shareholding in the registered share capital
of the Company or (ii) in case of a share transfer, the number of shares sold in the Liquidity Event (as applicable).

8.2 On a first preferred level (“First Preferred Level”), each holder of Series A Shares shall receive an amount equal

to its respective total investment made to acquire its respective Series A Shares held by it (consisting of the nominal
amount of the Series A Shares acquired by that holder and any share premium and/or other capital contribution (account
115) paid by the respective holder to the Company). If the Exit Proceeds do not suffice for the payments to be made on
the First Preferred Level, the Exit Proceeds shall be allocated to each holder of Series A Shares pro rata to the amounts
that would have been allocated to that holder on the First Preferred Level if the Exit Proceeds had been sufficient.

8.3 After the payments on the First Preferred Level have been made, the remaining Exit Proceeds shall be allocated

on a common level (“Common Level”) to all selling shareholders pro rata to the respective shares disposed of in con-
nection with the Liquidity Event. Any amounts received by any shareholder on the First Preferred Level shall reduce the
amount to be allocated to such shareholder on the Common Level; provided that no shareholder shall be obliged to
repay any amount received on the First Preferred Level. Any Exit Proceeds remaining unallocated after allocation under
this Article 8.3 shall also be allocated in accordance with this Article 8.3 by applying Article 8.3 repeatedly until all Exit
Proceeds have been allocated to the shareholders. Irrespective of whether or not the sale of shares is made in one or
more transactions, no shareholder shall receive for the sale of all of its shares (and repay any exceeding amount to the
other shareholder) an amount exceeding the higher of (i) its share in the total Exit Proceeds pro rata to the Shares sold
or (ii) the amount of its investment in the Company (payment of purchase price for shelf company, payment of share
capital, including premium, if any, and payments into account 115 of the standard chart of accountants “apport en capitaux
propres non rémunérés par des titres” under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg (additional amounts)) in
respect of the shares sold. If shares in the Company are sold in more than one transaction, no shareholder shall receive
less proceeds than it would have received if the shares in the Company were sold in one transaction.

8.4 The preferred allocation on the First Preferred Level applies for the benefit of the respective shareholder so long

as the respective shareholder (including any sales prior to a Liquidity Event) has not yet received the full amount that is
to be allocated to such shareholder according to the First Preferred Level.

Art. 9. Redemption of Shares.
9.1 The Company may redeem its own shares. The voting rights of any of its shares held by the Company are suspended,

for as long as they are held by the Company.

9.2 Shares of a shareholder may be redeemed without such shareholder’s consent, if:
9.2.1 insolvency proceedings are opened over the assets of the shareholder or the opening of insolvency proceedings

is rejected for lack of assets;

9.2.2 the share of a shareholder is seized or enforcement proceedings are otherwise initiated against such share and

such enforcement proceedings are not finally closed within two (2) months.

Upon receipt by such shareholder of the declaration of redemption sent by the board of managers, the shares shall

automatically be redeemed without any further action being required. The present articles together with the declaration
of redemption constitute together a valid instrument in writing for the purposes of article 190 of the Law and the Company
hereby acknowledges and accepts the transfer of the shares in such case and undertakes to register the transfer in its
share register and to proceed with the relevant filings required by law.

9.3 If the share is held by several persons, it is sufficient that the ground for redemption exists with respect to one

person; independently of this, several jointly entitled persons can only exercise the shareholders’ rights in a uniform way
through one jointly entitled person to be appointed for this purpose without undue delay after the joint entitlement
arises.

9.4 The board of managers may declare a redemption. The redemption declaration takes effect upon receipt of the

declaration by the shareholder concerned and if a respective shareholders’ resolution is adopted (except in case of Article
9.2 of these articles of association, in which no declaration by the shareholder concerned and no respective shareholders’
resolution is required).

Art. 10. Compensation for Redemption.
10.1 Redemption is made against compensation.
10.2 The compensation consists of a total amount equal to the market value of the redeemed shares. The effective

date is the date before the redemption resolution.

10.3 The compensation for redemption shall be due and payable immediately upon redemption of the shares.
10.4 The withdrawing shareholder shall not be entitled to request the Company to provide security for outstanding

amounts including interest.

10.5 In the event of dispute regarding the amount of the payable compensation for redemption, such compensation is

to be determined by an auditor as expert arbitrator who shall jointly be appointed by the shareholders. If no agreement
is reached, the expert arbitrator shall be selected by the President of the Tribunal d’Arrondissement upon request of a
shareholder or of the Company. The decision of the expert arbitrator shall be binding. The costs of the expert opinion
shall be borne by the Company and the requesting shareholder in equal parts, the part allocated to such shareholder shall

126218

L

U X E M B O U R G

be set off with the compensation for redemption and the compensation for redemption shall be reduced accordingly.
The  shareholder  shall  bear  the  remaining  costs  in  case  the  compensation  for  redemption  does  not  cover  the  costs
allocated to the shareholder for the expert opinion.

Art. 11. Request of Assignment in lieu of Redemption.
11.1 The Company may decide that, in lieu of redemption, the shareholder concerned shall transfer the shares to a

person named by the Company (including another shareholder of the Company), including also partial redemption or
partial assignment of the shares to the Company or to a person named by the Company.

11.2 This Article 11 applies with the proviso that the compensation, as provided for in Article 10 of these articles of

association, for the shares to be assigned is owed by the person acquiring the shares and that the Company shall be liable
like a guarantor.

C. Decisions of the shareholders

Art. 12. Collective Decisions of the Shareholders.
12.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these

articles of association.

12.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
12.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise

conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case,
each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his
vote in writing.

12.4 The shareholders’ resolutions are passed in meetings. Unless mandatory law prescribes another form, they can

also be passed outside meetings in writing (including e-mail or fax) or telephone voting if such procedure is requested by
a shareholder and no other shareholder declares its dissent with the procedure within two (2) weeks towards the board
of managers of the Company in written form. If no dissent is declared within the two (2) weeks pursuant to the foregoing
sentence, the votes of the shareholders which are not participating in the voting shall be deemed to be abstention from
voting. Written resolutions must be signed by each shareholder and the written record must be sent to each shareholder
without undue delay. Resolutions not passed in writing must be confirmed in writing. Such confirmation only has decla-
ratory significance.

12.5 Unless a notarial record is made of shareholders’ resolutions, a written record must be made of every resolution

passed at shareholders’ meetings (for purposes of proof, not as a precondition of validity) without undue delay, which
must state the date and form of the resolution passed, the content of the resolution and the votes cast. The written
record must be sent to each shareholder in writing without undue delay.

12.6 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of

shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by
the sole shareholder.

Art. 13. General Meetings of Shareholders.
13.1 Meetings of shareholders may be held at the registered office of the Company or at such place and time as may

be specified in the respective convening notices of meeting.

13.2  The  shareholders’  meeting  is  called  by  registered  letter  (registered  personal  delivery,  registered  delivery  or

registered letter with confirmation of receipt) to each shareholder, stating the place, date, time and agenda, with a period
of notice of at least four (4) weeks for ordinary shareholders’ meetings and at least two (2) weeks for extraordinary
shareholders’ meetings. The period of notice begins to run on the day following postage. The day of the shareholders’
meeting is not counted in the calculation of the period of notice.

13.3 If all shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived convening

requirements, the meeting may be held without prior notice.

13.4 Each shareholder is entitled to be accompanied or represented at the shareholders’ meeting by another share-

holder authorised by a written power of attorney or by a lawyer, tax advisor or auditor under a professional duty of
confidentiality.

13.5 Unless a notarial record is made of the negotiations of the shareholders’ meeting, a written record must be made

concerning the course of the meeting (for purposes of proof, not as a precondition of validity), which must state the place
and date of the meeting, the participants, the items on the agenda, the main content of the negotiations and the share-
holders’ resolutions. The written record must be signed by all shareholders present or represented in the shareholders’
meeting (for purposes of proof, not as a precondition of validity). Each shareholder must be sent a copy of the written
record.

Art. 14. Quorum and Vote.
14.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.

126219

L

U X E M B O U R G

14.2 A shareholders’ meeting only constitutes a quorum if at least fifty per cent (50%) of the share capital is represented.

Save for a higher majority provided in these articles of association or by Law, collective decisions of the Company’s
shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share
capital. If there is no quorum, a new shareholders’ meeting with the same agenda must be called without undue delay in
compliance with Article 13.2. This shareholders’ meeting then shall constitute a quorum regardless of the share capital
represented, if this was pointed out in the notice calling the meeting and the decisions shall be taken at the majority of
the votes cast.

Art. 15. Change of Nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous

consent.

Art. 16. Amendments of Articles of Association. Any amendment of these articles of association requires the approval

of (i) a majority in number of shareholders (ii) who are also a Super Majority.

Art. 17. Shareholders’ Resolutions Requiring Specific Majority.
17.1 Shareholders’ Resolutions regarding the following subjects must be taken by a Super Majority:
17.1.1  conclusion  of  intra-group  agreements  (Unternehmensverträge  within  the  meaning  of  sections  291  et  seqq.

German Stock Corporation Act (AktG));

17.1.2 conclusion of company participations (for the avoidance of doubt, other than by way of disposal of shares) of

any kind including silent partnerships and all agreements by which the other contractual party is granted a participation
in the Company’s profit or any payment that is dependent on the amount of the Company’s profit; this does not include
agreements with shareholders or employees of the Company, including agreements concluded in light of a prospective
status as shareholder or employee, as well as agreements with third parties within the ordinary course of business, e.g.
agreements between the Company and advertising partners.

17.2 Resolutions regarding the following subjects must be taken by a Super Majority and also require the prior consent

of the Investors:

17.2.1 material changes to the business object of the Company;
17.2.2 amendments of these articles of association;
17.2.3 exclusion of subscription rights in case of capital increases;
17.2.4 acquisition of the Company’s own shares, with the exception of acquisitions in accordance with Article 9.2 and

transfers in accordance with Article 11.1 of these articles of association;

17.2.5 disposition of all Company’s assets or of a significant part of the Company’s assets including the resolution with

respect to the liquidation of the Company;

17.2.6 merger, separation and transformation of the Company.
17.3. Whenever the capital of the Company is divided into different classes of shares, the specific rights and obligations

attached to any class may be varied or abrogated with the unanimous consent in writing of the shareholders who hold
all the issued shares of that class.

D. Board of managers

Art. 18. Powers of the Sole Manager - Composition and Powers of the Board of Managers.
18.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers

form a board of managers.

18.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not

expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of
association is to be construed as a reference to the “sole manager”.

18.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any

actions necessary or useful to fulfil the Company’s corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the
Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.

Art. 19. Election, Removal and Term of Office of Managers.
19.1 The manager(s) shall be elected by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration

and term of office.

19.2 The managers shall be elected and may be removed from office at any time, with or without cause.
19.3 The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two (2) different classes, being class A

managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant
shareholders resolutions and the managers be identified with respect to the class they belong.

Art. 20. Vacancy in the Office of a Manager.
20.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or

otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of

126220

L

U X E M B O U R G

the  replaced  manager by  the remaining managers  until  the next meeting  of shareholders  which  shall  resolve on the
permanent appointment, in compliance with the applicable legal provisions.

20.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company’s sole manager, such vacancy must be filled without undue

delay by the general meeting of shareholders.

Art. 21. Convening Meetings of the Board of Managers.
21.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held

at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.

21.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers at least twenty-four (24)

hours in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such document being
sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined
in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.

21.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive

any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of
managers.

Art. 22. Management.
22.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not

need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

22.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may

appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any
such meeting.

22.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either

in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.

22.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other

means of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis
and allowing an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a
participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.

22.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or

represented at a meeting of the board of managers.

22.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,

if any, shall not have a casting vote. In the event, however, the general meeting of shareholders has appointed different
classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only
be validly taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which
may be represented).

22.7 The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in

writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be
the date of the last signature.

22.8 The managers shall require the consent of a shareholder or shareholders holding jointly more than fifty per cent

(50%) of the share capital in the Company (the "Simple Majority") for the legal transactions and measures specified below.
No consent is required if such legal transactions and measures have been precisely defined and have in advance been
approved by an adopted budget with the consent of the Simple Majority:

22.8.1 formation, acquisition, closure or disposal of enterprises or partial-businesses;
22.8.2 amendment of statutes, these articles of association, shareholder agreements and similar contracts as well as

exercise (or waiver) of shareholders’ rights in companies in which an interest is held;

22.8.3 acquisition, sale and encumbrance of real estate and similar rights or rights in real estate;
22.8.4 establishment, relocation and closure of branch establishments and places of business;
22.8.5 modification of the fields of business of the Company and the termination of existing and commencement of

new fields of business (Geschäftsfelder);

22.8.6 approval of the annual plan, in particular the budget plan for each following year;
22.8.7 assumption of sureties, guarantees or similar liabilities in excess of an amount of two hundred thousand Euros

(EUR 200,000.00) in aggregate;

22.8.8 granting of loans in excess of two hundred thousand Euros (EUR 200,000.00) in the individual case, excluding,

however, such loans between the Company and direct and indirect subsidiaries of the Company;

126221

L

U X E M B O U R G

22.8.9 conclusion and termination of credit and loan agreements and other financial agreements in excess of two

hundred thousand Euros (EUR 200,000.00) in the individual case and amendments to the credit framework and extraor-
dinary repayments, excluding, however, such agreements between the Company and direct and indirect subsidiaries of
the Company;

22.8.10 futures transactions concerning currencies, securities and exchange-traded goods and rights as well as other

transactions with derivative financial instruments;

22.8.11 granting, introduction and amendment of pension commitments of any kind;
22.8.12 conclusion, amendment and dissolution of employment contracts providing for a remuneration in excess of

one hundred fifty thousand Euros (EUR 150,000) per year;

22.8.13 promise or granting of bonuses and gratuities of any kind outside of existing employment contracts as well as

payment of advances or grant of loans to managers and employees in excess of fifty thousand Euros (EUR 50,000) in the
individual case;

22.8.14 conclusion, amendment or termination of Company collective agreements, works agreements (of substantial

importance) and of general guidelines regarding the Company pension scheme;

22.8.15 institution and termination of legal disputes, in particular, arbitration proceedings involving a judicial amount

in controversy of more than ten thousand Euros (EUR 10,000.00) in the individual case;

22.8.16 acquisition, disposition and/or licensing of rights of use of any kind with respect to intellectual property rights

including copyrights or any other property rights as well as the passing on of know-how for the independent exploitation
by  the  enterprise  and/or  a  third  party,  as  well  as  the  grant  or  acquisition  of  licences,  as  well  as  the  amendment  of
agreements with respect thereto, excluding, however, such dispositions between the Company and direct and indirect
subsidiaries of the Company;

22.8.17 granting of a power of attorney, by which a proxy grants power of attorney to another proxy, in order to

conclude an agreement with him at the expense of the Company;

22.8.18 transactions of the Company and its investment companies with affiliated legal entities and individuals. As such

shall be deemed to be direct or indirect shareholders of the Company (including, for the avoidance of doubt, European
Founders Fund GmbH (“EFF”) and EFF’s direct and indirect shareholders (i.e. the Samwer brothers), but excluding any
direct or indirect shareholders of ES, Aismare and/or Eiffel), affiliated companies pursuant to sections 15 et seqq. German
Stock Corporation Act (AktG) as well as relatives pursuant to section 15 German Tax Code (AO) of direct or indirect
shareholders, as far as the latter (except EFF and EFF’s direct and indirect shareholders) - individually or jointly - hold,
directly or indirectly, a majority interest. The consent requirement pursuant to this Article 22.8.18 does not apply if the
transaction belongs to the ordinary course of business of the Company and is at arm’s length;

22.8.19 changing of the Company’s auditors;
22.8.20 granting, setting up or amending any employee incentive scheme (including the grant of any share options)

outside the existing simplified employee participation agreed upon between the shareholders in a shareholders’ agree-
ment;

22.8.21 exercise of voting rights and other rights in a company in which the Company is a shareholder to the extent

that this exercise would require the consent of the Simple Majority under these articles of association if the Company
was concerned, i.e. according to this Article 22.8 or Article 17.

22.9 If the consent is required as aforesaid for the acquisition, sale or encumbrance of objects, the consent is also

required for the contractual obligation relating thereto. The shareholders’ meeting may by resolution determine further
transactions and measures requiring the consent of a Simple Majority. The Simple Majority may give its consent also in
advance for certain groups and kinds of transactions and measures.

22.10 The shareholders may by shareholders’ resolution adopt rules of procedure for the managers.
22.11 The management shall ensure that, as far as legally possible, the regulations in this Article 22 apply in the same

manner to all related companies in which the Company holds a majority interest, directly or indirectly, at present or in
the future.

Art. 23. Minutes of the Meeting of the Board of Managers; Minutes of the Decisions of the Sole Manager.
23.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by

the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. In the event the general meeting of
shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers), such minutes
shall be signed by one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation). Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman,
if any, or by any two (2) managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of
managers (namely class A managers and class B managers), such copies or excerpts shall be signed by one (1) class A
manager and one (1) class B manager (including by way of representation).

23.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or

excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.

126222

L

U X E M B O U R G

Art. 24. Dealing with Third Parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the

signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers;
in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A manager
and class B manager), the Company will only be validly bound by the joint signature of at least one (1) class A manager
and one (1) class B manager (including by way of representation) or (ii) by the joint signatures or the sole signature of
any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such
delegation.

Art. 25. Advisory Board.
25.1 The Company shall have an advisory board. It shall consist of four (4) voting members. The shareholders’ meeting

may by way of a unanimous shareholders’ resolution increase or decrease the number of voting members of the advisory
board.

25.2 The shareholders’ meeting shall only set and/or amend rules of procedure for the advisory board by way of a

unanimous shareholders’ resolution.

25.3 The voting members of the advisory board shall be nominated, withdrawn or replaced by each member’s res-

pective appointing shareholder by written notification towards the Company as follows:

25.3.1 Three (3) voting members of the Advisory Board shall be nominated by the shareholder Rocket (“Rocket

Members”) in its sole discretion; and

25.3.2  One  (1)  voting  member  of  the  Advisory  Board  shall  be  nominated  by  the  shareholder  Aismare  in  its  sole

discretion.

25.4 Each shareholder other than those entitled to appoint a voting member of the Advisory Board pursuant to Article

25.3 shall be entitled to appoint a non-voting member to the Advisory Board as an observer.

25.5 The advisory board shall have a chairman and a deputy chairman. A Rocket Member shall be the chairman of the

Advisory Board. The rules of procedure of the advisory board may provide for further provisions in particular on the
self-organization of the advisory board. The advisory board shall adopt resolutions with the simple majority of votes cast.
The advisory board shall hold meetings on a regular basis, at least once every calendar quarter.

25.6 The advisory board shall be competent for advising the Company’s managers on the strategy and operational

matters as well as any other matters of substantial importance (including but not limited to potential IPO plans, intentions
to substantially raise equity and/or debt) and shall discuss with the managers the budget of the Company.

25.7 The advisory board is not a supervisory board within the meaning of article 60bis-11 et seq. of the Law.

E. Audit and supervision

Art. 26. Auditor(s).
26.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company

shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.

26.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting

of shareholders.

26.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
26.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d’entreprises agréé

(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies’ register and the
accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.

26.5 An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its

approval.

F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends

Art. 27. Financial Year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end

on the thirty-first of December of the same year.

Art. 28. Annual Accounts and Allocation of Profits.
28.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of

the Company’s assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.

28.2 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve.

This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten
per cent (10%) of the share capital of the Company.

28.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the

contributing shareholder agrees with such allocation.

28.4 In case of a share capital reduction, the Company’s legal reserve may be reduced in proportion so that it does

not exceed ten per cent (10%) of the share capital.

126223

L

U X E M B O U R G

28.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the

remainder of the Company’s annual net profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.

28.6 Subject to Article 8, distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they

hold in the Company.

Art. 29. Interim Dividends - Share Premium and Assimilated Premiums.
29.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared

by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed shall
be allocated where applicable and may not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by
profits carried forward and distributable reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to
a reserve which the Law or these articles of association do not allow to be distributed.

29.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the share-

holders subject to the provisions of the Law and these articles of association.

G. Liquidation

Art. 30. Liquidation. In the event of dissolution of the Company in accordance with Article 3.2 of these articles of

association, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting
of shareholders deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless other-
wise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realization of the assets and payment of the
liabilities of the Company.

H. Final clause - Governing law

Art. 31. Governing Law.
31.1 All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the Law and any

shareholders’ agreement which may be entered into from time to time between the shareholders and the Company, and
which may supplement certain provisions of these articles. Where any matter contained in these articles conflicts with
the provisions of any shareholders’ agreement, such shareholders’ agreement shall prevail inter partes and to the extent
permitted by Luxembourg law.

31.2 These articles are worded in English followed by a German translation; in case of divergence between the English

and the German text, the English version shall prevail.”

6. Miscellaneous.
Having duly considered each item of the agenda, the general meeting of shareholders unanimously takes the following

resolutions:

<i>First resolution

The general meeting of shareholders decides to create two (2) classes of shares in the share capital of the Company,

so that the Company will hence have two (2) classes of shares, represented by common shares (hereinafter “Common
Shares”) and series A shares (hereinafter “Series A Shares”) and to convert the existing twelve thousand five hundred
(12,500) shares, with a nominal value of one euro (EUR 1) each, into twelve thousand five hundred (12,500) Common
Shares, with a nominal value of one euro (EUR 1) each, without cancellation of shares.

<i>Second resolution

The general meeting of shareholders accepts (i) Netris B.V., (ii) Aismare Lux Holdings S.à r.l. and (iii) JP Ventures UG

(haftungsbeschränkt), aforementioned, as new shareholders of the Company.

<i>Third resolution

The general meeting of shareholders resolves to increase the share capital of the Company by an amount of one

thousand seven hundred nine euro (EUR 1,709) so as to raise it from its current amount of twelve thousand five hundred
euro (EUR 12,500) up to fourteen thousand two hundred nine euro (EUR 14,209) by issuing one thousand seven hundred
nine (1,709) Series A Shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.

<i>Subscription

The one thousand seven hundred nine (1,709) Series A Shares have been duly subscribed as follows:
- Four hundred seventeen (417) Series A Shares have been subscribed by Eiffel, aforementioned, here represented as

aforementioned, for the price of four hundred seventeen euro (EUR 417);

- One thousand two hundred fifty (1,250) Series A Shares have been subscribed by Aismare, aforementioned, here

represented as aforementioned, for the price of one thousand two hundred fifty euro (EUR 1,250);

- Forty-two (42) Series A Shares have been subscribed by ES, aforementioned, here represented as aforementioned,

for the price of forty-two euro (EUR 42).

126224

L

U X E M B O U R G

<i>Payment

The one thousand seven hundred nine (1,709) Series A Shares subscribed by Eiffel, Aismare, ES, aforementioned, have

been entirely paid up through a contribution in cash in an amount of one thousand seven hundred nine euro (EUR 1,709).

The amount of one thousand seven hundred and nine euro (EUR 1,709) is as now available to the Company as has

been proved to the undersigned notary.

The contribution in the amount of one thousand seven hundred nine euro (EUR 1,709) is entirely allocated to the

share capital.

<i>Fourth resolution

The general meeting of shareholders resolves the amendment of article five point one (5.1) of the articles of association

of the Company so that it shall now henceforth read as follows:

“ Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company’s share capital is set at fourteen thousand two hundred nine Euros (EUR 14,209.00), represented

by

5.1.1 twelve thousand five hundred (12,500) common shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each (he-

reinafter “Common Shares”), and

5.1.2 one thousand seven hundred nine (1,709) series A shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each

(hereinafter “Series A Shares”, the Series A Shares hereinafter also referred to as “Preferred Shares”).

The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by these

articles of association or by the Law.”

<i>Fifth resolution

Inter alia as a result of the foregoing, the general meeting of shareholders unanimously resolves to fully restate the

articles of association of the Company which shall henceforth read as set out in the agenda of the present deed.

There being no further business, the meeting is closed.

<i>Costs and expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are

estimated at approximately EUR 2,500.-.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,

the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing parties
and in case of divergence between the English and the German text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name

and residence, the said proxyholder signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausendvierzehn, am zehnten Juli.
Vor uns, dem unterzeichnenden Notar Maître Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxem-

burg.

SIND ERSCHIENEN:

1. Rocket Internet AG (vormals Rocket Internet GmbH), eine Aktiengesellschaft bestehend unter deutschem Recht,

mit  satzungsmäßigem  Sitz  in  Berlin,  Deutschland,  eingetragen  im  Handelsregister  des  Amtsgerichts  Charlottenburg,
Deutschland, unter der Nummer HRB 159634 B, mit Geschäftssitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Deutschland,

Inhaber von zehntausend (10.000) Anteilen der Gesellschaft,
hier vertreten durch Frau Alix van der Wielen, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht

vom 8. Juli 2014, ausgestellt in Berlin, Deutschland;

2. Bambino 53. V V UG (haftungsbeschränkt), eine Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) bestehend unter

deutschem Recht, mit satzungsmäßigem Sitz in Berlin, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts
Charlottenburg, Deutschland, unter der Nummer HRB 126893 B, mit Sitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Deutschland,

Inhaber von zweitausendfünfhundert (2.500) Anteilen der Gesellschaft,
hier vertreten durch Frau Alix van der Wielen, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht

vom 4. Juli 2014, ausgestellt in Berlin, Deutschland;

3. Netris B.V., eine Besloten Vennootschap nach dem Recht der Niederlande, mit Sitz in Schiphol, Niederlande, ein-

getragen  im  Handelsregister  des  Dutch  Trade  Register  unter  der  Nummer  60628022,  mit  Geschäftssitz  in  Schiphol

126225

L

U X E M B O U R G

Boulevard 127, 1118BG Schiphol, Niederlande („Eiffel“), ausschließlich für die Punkte 4 ff. der Tagesordnung teilnahme-
und stimmberechtigt,

zukünftiger Inhaber von vierhundertsiebzehn (417) Anteilen der Serie A der Gesellschaft,
hier vertreten durch Frau Alix van der Wielen, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht

vom 4. Juli 2014, ausgestellt in Schiphol, Niederlande;

4. Aismare Lux Holdings S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) gegründet

und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handelsund Gesell-
schaftsregister unter der Nummer B 176.544, mit Sitz in 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Großherzogtum
Luxemburg, mit einem Gesellschaftskapital von dreiundvierzigtausend Euro (EUR 43.000) („Aismare“), ausschließlich für
die Punkte 4 ff. der Tagesordnung teilnahme- und stimmberechtigt,

zukünftiger Inhaber von eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Anteilen der Serie A der Gesellschaft,
hier vertreten durch Frau Alix van der Wielen, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht

vom 3. Juli 2014, ausgestellt in Munsbach, Großherzogtum Luxemburg;

5. JP Ventures UG (haftungsbeschränkt), eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung bestehend unter deutschem Recht,

mit satzungsmäßigem Sitz in Wehingen, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart, Deutsch-
land, unter der Nummer HRB 733673 B, mit Geschäftssitz in Gosheimerstraße 48, 78564 Wehingen, Deutschland, („ES“,
gemeinschaftlich mit Eiffel und Aismare die „Neuen Investoren“), ausschließlich für die Punkte 4 ff. der Tagesordnung
teilnahme- und stimmberechtigt,

zukünftiger Inhaber von zweiundvierzig (42) Anteilen der Serie A der Gesellschaft,
hier vertreten durch Frau Alix van der Wielen, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht

vom 7. Juli 2014, ausgestellt in New York, Vereinigte Staaten von Amerika.

Besagte Vollmachten, welche von der Bevollmächtigten der erschienenen Parteien und dem Notar ne varietur para-

phiert wurden, werden der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.

Die Parteien 1 und 2 (die „Bestehenden Gesellschafter“) sind alle Gesellschafter der Helpling Group Holding S.à r.l.

(die „Gesellschaft”), einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), gegründet und beste-
hend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum
Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 184.677, gegründet
am 7. Februar 2014 gemäß einer Urkunde des unterzeichnenden Notars, welche am 28. April 2014 im Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, Nummer 1074 veröffentlicht wurde. Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt am 10. Juni
2014 gemäß einer Urkunde des unterzeichnenden Notars geändert, welche noch nicht im Mémorial C, Recueil des So-
ciétés et Associations veröffentlicht wurde.

Da die Bestehenden Gesellschafter das gesamte Gesellschaftskapital vertreten und auf jegliche Ladungsformalitäten

verzichtet haben, ist die Gesellschafterversammlung ordnungsgemäß zusammengekommen und kann wirksam über die
folgende Tagesordnung verhandeln, wobei die Neuen Investoren ausschließlich für die Punkte 4 ff. der Tagesordnung
teilnahme- und stimmberechtigt sind:

<i>Tagesordnung

1. Beschluss bezüglich der Schaffung von zwei (2) Anteilsklassen im Gesellschaftskapital der Gesellschaft, sodass die

Gesellschaft nunmehr zwei (2) Anteilsklassen hat, bestehend aus Stammanteilen (die „Stammanteile“) und Anteilen der
Serie A (die „Anteile der Serie A“) und bezüglich der Umwandlung ohne Einziehung von Anteilen der bestehenden zwölf-
tausendfünfhundert (12.500) Anteile mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1) in zwölftausendfünfhundert
(12.500) Stammanteile mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1).

2. Aufnahme von (i) Netris B.V., einer Besloten Vennootschap nach dem Recht der Niederlande, mit Sitz in Schiphol,

Niederlande, eingetragen im Handelsregister des Dutch Trade Register unter der Nummer 60628022, mit Geschäftssitz
in Schiphol Boulevard 127, 1118BG Schiphol, Niederlande, (ii) Aismare Lux Holdings S.à r.l., einer Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung (société à responsabilité limitée) gegründet und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums
Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 176.544, mit Sitz in
6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Großherzogtum Luxemburg, mit einem Gesellschaftskapital von dreiund-
vierzigtausend Euro (EUR 43.000) und (iii) JP Ventures UG (haftungsbeschränkt), einer Gesellschaft mit beschränkter
Haftung bestehend unter deutschem Recht, mit satzungsmäßigem Sitz in Wehingen, Deutschland, eingetragen im Han-
delsregister des Amtsgerichts Stuttgart, Deutschland, unter der Nummer HRB 733673 B, mit Geschäftssitz in Goshei-
merstraße 48, 78564 Wehingen, Deutschland, als neue Gesellschafter der Gesellschaft.

3. Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von zwölftausendfünfhundert

Euro (EUR 12.500) um einen Betrag von eintausendsiebenhundertneun Euro (EUR 1.709) auf einen Betrag von vierzehn-
tausendzweihundertneun Euro (EUR 14.209) durch die Ausgabe von eintausendsiebenhundertneun (1.709) Anteilen der
Serie A mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1).

4. Dementsprechende Änderung des Artikels fünf Punkt eins (5.1) der Satzung der Gesellschaft, welcher nunmehr wie

folgt lautet:

126226

L

U X E M B O U R G

„ Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt vierzehntausendzweihundertneun Euro (EUR 14.209,00), beste-

hend aus

5.1.1  zwölftausendfünfhundert  (12.500)  Stammanteilen  mit  einem  Nominalwert  von  je  einem  Euro  (EUR  1)  (die

„Stammanteile”), und

5.1.2 eintausendsiebenhundertneun (1.709) Anteilen der Serie A mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1)

(die „Anteile der Serie A“, die im Folgenden auch als „Vorzugsanteile“ bezeichnet werden).

Die mit den Anteilen verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es wird in dieser Satzung oder

durch das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.“

5. Vollständige Neufassung der Satzung der Gesellschaft, welche nunmehr wie folgt lautet:

„A. Name - Zweck - Dauer - Sitz

Art. 1. Name. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen

Helpling Group Holding S.à r.l. (die „Gesellschaft”), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über
Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Ge-

sellschaften, sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung
oder auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung,
Kontrolle und Entwicklung ihrer Beteiligungen.

2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder

Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören Garantien geben,
Sicherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.

2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere

durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und
Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheinen bzw. Wertpapieren.

2.4 Der Zweck der Gesellschaft ist auch (i) der Erwerb durch Kauf, Eintragung oder in jeder anderen Form, sowie die

Übertragung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Art von geistigem Eigentum und gewerblichen Schutzrechten, (ii)
die Erteilung von Lizenzen bezüglich solchem geistigem Eigentum und solcher gewerblicher Schutzrechte, und (iii) das
Innehaben und die Verwaltung von geistigem Eigentum und gewerblichen Schutzrechten.

2.5 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur, sowie

solche, welche geistiges Eigentum oder Grundeigentum betreffen, vornehmen, die ihr zur Erreichung dieser Zwecke
förderlich erscheinen, im Hinblick auf deren Verwertung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Art.

Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden,

welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird.

Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Rates der Geschäftsführer

verlegt werden. Durch einen Gesellschafterbeschluss, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und
Weise gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer im

Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.

4.4 Sollte der Rat der Geschäftsführer entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale

Entwicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an
ihrem  Gesellschaftssitz  beeinträchtigen  könnten,  so  kann  der  Gesellschaftssitz  bis  zur  endgültigen  Beendigung  dieser
außergewöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben
keine Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes
eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt vierzehntausendzweihundertneun Euro (EUR 14.209,00), beste-

hend aus

5.1.1  zwölftausendfünfhundert  (12.500)  Stammanteilen  mit  einem  Nominalwert  von  je  einem  Euro  (EUR  1)  (die

„Stammanteile”), und

126227

L

U X E M B O U R G

5.1.2 eintausendsiebenhundertneun (1.709) Anteilen der Serie A mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1)

(die „Anteile der Serie A“, die im Folgenden auch als „Vorzugsanteile“ bezeichnet werden).

Die mit den Anteilen verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es wird in dieser Satzung oder

durch das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.

5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-

zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.

5.3 Jeder der Gesellschafter Rocket Internet AG („Rocket“), Netris B.V. („Eiffel“), JP Ventures UG (haftungsbeschränkt)

(„ES“) und/oder Aismare Lux Holdings S.à r.l. („Aismare“, gemeinschaftlich mit Rocket, ES und Eiffel die „Investoren“ und
jeweils ein „Investor“) ist zur Zeichnung einer Anzahl weiterer bei einer Kapitalerhöhung ausgegebener Anteile berechtigt,
wodurch ein Investmentangebot eines Dritten umgesetzt wird (bei dem es sich weder um einen Gesellschafter, noch um
eine mit einem Gesellschafter verbundene Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG) (ein
„Drittinvestor“) handelt), der mit einer Mehrheit von mindestens fünfundsiebzig Prozent (75%) der Stimmen aller Ge-
sellschafter der Gesellschaft zugestimmt wurde (wobei eine solche Mehrheit als „Qualifizierte Mehrheit“ und eine solche
Investition als „Investition eines Dritten“ bezeichnet wird) - unabhängig davon, ob diese vom Drittinvestor oder von
einem oder mehreren vergleichbaren Gesellschaftern erfolgte - und die zur Erhaltung der Beteiligungsquote an der Ge-
sellschaft vor einer solchen Kapitalerhöhung erforderlich ist, und dies zu denselben Bedingungen, wie bei einer Investition
eines Dritten. Der jeweilige Investor hat die Gesellschaft durch eine verbindliche Erklärung innerhalb von drei (3) Wochen
darüber zu unterrichten, ob er sein Recht gemäß des vorstehenden Satzes dieses Artikels 5.3 ausüben möchte, wobei die
Investition eines Dritten nach Ablauf dieser Frist (soweit nicht von den Investoren nach diesem Artikel 5.3 übernommen)
durchgeführt wird.

Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit jeweils dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht über-

schreiten darf.

6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs oder die Insol-

venz oder ein vergleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.

6.5 Die Gesellschaft kann Einlagen ohne Ausgabe von Anteilen oder anderen Sicherheiten als Gegenleistung annehmen

und diese einer oder mehreren ausschüttbaren Rücklagen zuführen. Entscheidungen bezüglich der Verwendung solcher
ausschüttbarer Rücklagen werden gegebenenfalls von dem(den) Gesellschafter(n) oder Geschäftsführer(n) unter Berück-
sichtigung des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung getroffen.

Art. 7. Anteilsregister - Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden

kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.

7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten

wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft
ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.

7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.
7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung einer Qualifizierten Mehr-

heit  und  vorbehaltlich  der  Bestimmungen  von  Gesellschaftervereinbarungen  zwischen  den  Gesellschaftern,  sofern
vorhanden,  insbesondere  vorbehaltlich  Vorkaufsrechten,  Bezugsrechten  oder  Mitverkaufsrechten-  oder  Pflichten  aus
Gesellschaftervereinbarungen zwischen den Gesellschaftern übertragen werden. Sofern eine solche Zustimmung erteilt
wurde, ist eine weitere Einwilligung zur Übertragung von Anteilen nicht erforderlich:

7.4.1 bei einer Übertragung, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen durch einen Investor an

eine mit dem betreffenden Investor verbundene Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG);

7.4.2 bei einem Verkauf, einer Übertragung, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen durch

einen Investor an eine Gesellschaft, (x) welche direkt oder indirekt (i) diesen Investor oder (ii) einen oder mehrere direkte
oder indirekte Gesellschafter des betreffenden Investors (jeweils eine „Kontrollierte Gesellschaft“) Kontrolliert, von
diesem Kontrolliert Wird, oder unter der gemeinsamen Kontrolle von diesem steht, wobei die Worte „Kontrolle“ oder
„Kontrolliert Wird“ oder „Kontrolliert“ die direkte oder indirekte Beherrschung der Gesellschaft bezeichnet, durch (a)
die Leitung der Gesellschaft als geschäftsführender Gesellschafter, (b) das Halten der Mehrheit der Anteile oder (c) das
Halten der Mehrheit der Stimmrechte durch eine vertragliche Stimmvereinbarung, oder (d) die einseitige Fähigkeit, direkt
oder indirekt die Leitung der Geschäftsführung und Handlungsweisen einer Person, entweder durch das Halten stimm-
berechtigter Wertpapiere oder anderweitig, zu beeinflussen, oder (y) in welcher der betreffende Investor oder einer
oder mehrere Gesellschafter dieses Investors eine direkte oder indirekte Mehrheitsbeteiligung haben;

126228

L

U X E M B O U R G

7.4.3  bei  einer  Übertragung,  einer  Abtretung  oder  einer  anderen  Veräußerung  von  Anteilen  (i)  an  einen  Dritten,

welcher  Anteile  unter  der  vereinfachten  Mitarbeiterbeteiligung  erwirbt,  oder  (ii)  an  die  Gesellschaft  und/oder  einen
beliebigen Investor gemäß einer Call-Option im Zusammenhang mit einer Vesting-Regelung;

7.4.4 bei einer Übertragung, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen im Rahmen von Um-

wandlungsvorgängen  gemäß  des  Umwandlungsrechts  Luxemburgs,  insbesondere  (jedoch  nicht  beschränkt  auf)  eine
Verschmelzung der Gesellschaft, sofern die Gesellschafter der Gesellschaft nach einem solchen Umwandlungsvorgang
mehr als fünfzig Prozent (50%) an einer überlebenden juristischen Person halten.

7.5 In den in Artikel 7.4.1 bis 7.4.4 vorgesehenen Fällen gelten weder Verpflichtungen zu Verkaufsangeboten, noch

Vorkaufsrechte, Bezugsrechte oder Mitverkaufsrechte- oder Pflichten zugunsten anderer Gesellschafter.

7.6 Eine Übertragung, eine Abtretung oder eine andere Veräußerung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft

und Dritten gemäß Artikel 1690 des Code Civil wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung, Abtretung oder
anderen Veräußerung in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung, Abtretung oder anderen Veräußerung zugestimmt
hat.

7.7 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters nur an neue Gesellschafter übertragen werden,

wenn einer solchen Übertragung mit einer Qualifizierten Mehrheit zugestimmt wird (wobei die Anteile des verstorbenen
Gesellschafters für diese Zwecke nicht berücksichtigt werden). Eine derartige Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn
die Anteile an Eltern, Nachkommen oder den/die überlebende/n Ehepartner/in oder jeden anderen gesetzlichen Erben
des verstorbenen Gesellschafters übertragen werden.

Art. 8. Liquidations- und Verkaufspräferenzen.

8.1  Im  Falle  (i)  eines  Verkaufs  von  mindestens  fünfzig  Prozent  (50%)  aller  Anteile  an  der  Gesellschaft  oder  eines

Tausches oder einer Übernahme der Gesellschaft in wirtschaftlich vergleichbarer Weise in einer oder mehreren ver-
bundenen Transaktionen oder in zeitlicher Nähe zueinander, oder (ii) der Liquidation der Gesellschaft oder (iii) eines
Verkaufs oder einer Übertragung von Anteilen an der Gesellschaft entweder an Dritte oder an andere Gesellschafter,
was dazu führen würde, dass entweder mehr als fünfzig Prozent (50%) des eingetragenen Gesellschaftskapitals oder mehr
als fünfzig Prozent (50%) der Stimmrechte im Besitz der erwerbenden Partei bzw. Parteien wären (change of control),
als Ergebnis eines oder mehrerer verbundener Akquisitionen, (wobei jeder der unter (i), (ii) und (iii) beschriebenen Fälle
im Folgenden als „Liquiditätsereignis“ bezeichnet wird), werden die Erlöse („Exiterlöse“) -vorbehaltlich des Artikels 8.2
- im Einklang mit Artikel 8.3 auf einer pro rata-Basis (i) entsprechend ihrer Beteiligung am eingetragenen Gesellschafts-
kapital der Gesellschaft im Falle einer Vermögensübertragung, oder (ii) entsprechend der Anzahl der im Liquiditätsereignis
verkauften Anteile (soweit anwendbar) im Falle einer Anteilsübertragung, an die Gesellschafter verteilt.

8.2 Auf einer ersten Vorzugsebene („Erste Vorzugsebene”) erhält jeder Inhaber von Anteilen der Serie A einen Betrag,

welcher  dem  Betrag  seiner  jeweiligen  Gesamtinvestition  entspricht,  die  er  getätigt  hat,  um  seine  jeweiligen  von  ihm
gehaltenen Anteile der Serie A zu erwerben (bestehend aus dem Nominalbetrag der von diesem Inhaber erworbenen
Anteile der Serie A und dem Agio und/oder anderen Kapitaleinlage (Konto 115 des Standardisierten Luxemburgischen
Kontenplans), die von dem jeweiligen Inhaber an die Gesellschaft gezahlt wurden). Sind nicht ausreichend Exiterlöse für
die Zahlungen auf der Ersten Vorzugsebene vorhanden, so werden die Exiterlöse an jeden Inhaber der Anteile der Serie
A auf einer pro-rata Basis zu den Beträgen verteilt, die an diesen Inhaber auf der Ersten Vorzugsebene verteilt worden
wären, wenn ausreichend Exiterlöse vorhanden gewesen wären.

8.3 Nachdem die Zahlungen auf der Ersten Vorzugsebene geleistet wurden, werden die übrigen Exiterlöse auf einer

gemeinsamen Ebene („Gemeinsame Ebene“) an alle verkaufenden Gesellschafter auf einer pro rata-Basis entsprechend
den jeweiligen Anteilen, die im Zusammenhang mit dem Liquiditätsereignis veräußert wurden, verteilt. Sämtliche von
einem Gesellschafter auf der Ersten Vorzugsebene erhaltenen Beträge mindern den von diesem Gesellschafter zu erhal-
tenden Betrag auf der Gemeinsamen Ebene; mit der Maßgabe, dass kein Gesellschafter zur Rückzahlung eines auf der
Ersten Vorzugsebene erhaltenen Betrags verpflichtet ist. Exiterlöse, welche nach der Verteilung gemäß dieses Artikels
8.3 nicht zugeteilt wurden, werden auch im Einklang mit diesem Artikel 8.3 durch die wiederholte Anwendung des Artikels
8.3 verteilt, bis alle Exiterlöse an die Gesellschafter verteilt wurden. Unabhängig davon, ob der Verkauf von Anteilen in
einer oder mehreren Transaktionen erfolgt oder nicht, hat kein Gesellschafter für den Verkauf all seiner Anteile einen
Betrag zu erhalten (und übersteigende Beträge an die anderen Gesellschafter zurückzuzahlen), der höher ist, (i) als sein
Anteil an der Gesamtheit der Exiterlöse auf einer pro rata-Basis zu den verkauften Anteilen, oder (ii) als der Betrag seiner
Investition in die Gesellschaft (Zahlung des Kaufpreises für eine eventuelle Vorratsgesellschaft, Einzahlung des Gesell-
schaftskapitals,  einschließlich  ggf.  des  Agios,  und  Einzahlungen  auf  Konto  115  des  Standardisierten  Luxemburgischen
Kontenplans „apport en capitaux propres non rémunérés par des titres“ nach dem Recht des Großherzogtums Luxem-
burg  (zusätzliche  Beträge))  in  Bezug  auf  die  verkauften  Anteile.  Werden  Anteile  der  Gesellschaft  in  mehr  als  einer
Transaktion verkauft, so hat kein Gesellschafter weniger Erlöse zu erhalten, als er erhalten hätte, wenn die Anteile der
Gesellschaft in einer Transaktion verkauft worden wären.

8.4 Die bevorzugte Zuteilung auf der Ersten Vorzugsebene gilt zugunsten des entsprechenden Investors solange, wie

dieser (einschließlich von Verkäufen vor einem Liquiditätsereignis) den vollständigen Betrag, der an diesen Gesellschafter
gemäß der Ersten Vorzugsebene zu verteilen ist, noch nicht erhalten hat.

126229

L

U X E M B O U R G

Art. 9. Rückkauf von Anteilen.
9.1 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen. Die Stimmrechte der von der Gesellschaft gehaltenen

Anteile werden so lange ausgesetzt, wie die Anteile von der Gesellschaft gehalten werden.

9.2 Anteile eines Gesellschafters können ohne Zustimmung eines solchen zurückgekauft werden, wenn:
9.2.1 ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des Gesellschafters eröffnet wird oder die Eröffnung eines Insolvenz-

verfahrens mangels Masse abgelehnt wird;

9.2.2 der Anteil des Gesellschafters gepfändet wurde oder Vollstreckungsverfahren anderweitig gegen diesen Anteil

eingeleitet wurden und diese Verfahren nicht innerhalb von zwei (2) Monaten vollständig eingestellt sind.

Mit Erhalt durch den Gesellschafter der vom Rat der Geschäftsführer gesendeten Rückkaufserklärung sind die Anteile

automatisch zurückgekauft, ohne dass es einer weiteren Handlung bedarf. Die vorliegende Satzung stellt gemeinsam mit
der Rückkaufserklärung ein gültiges Dokument im Sinne des Artikels 190 des Gesetzes von 1915 dar und die Gesellschaft
bestätigt hiermit die Kenntnisnahme der Übertragung der Anteile, akzeptiert diese und verpflichtet sich zur Eintragung
dieser Übertragung in ihrem Anteilsregister und zur entsprechenden gesetzlich geforderten Hinterlegung für diesen Fall.

9.3 Wird der Anteil von mehreren Personen gehalten, ist das Vorliegen eines Grundes zum Rückkauf in Bezug auf eine

Person ausreichend; unabhängig davon können mehrere gemeinschaftlich berechtigte Personen die Gesellschafterrechte
nur dann und einheitlich ausüben, wenn eine der gemeinschaftlich berechtigten Personen unverzüglich nach Eintritt der
gemeinschaftlichen Berechtigung zu diesem Zwecke ernannt wird.

9.4 Ein Rückkauf kann durch den Rat der Geschäftsführer erklärt werden. Die Rückkaufserklärung wird wirksam, sobald

der betreffende Gesellschafter die Erklärung erhält und ein entsprechender Gesellschafterbeschluss gefasst wird (außer
im Falle von Artikel 9.2 dieser Satzung, in welchem keine Erklärung des Gesellschafters und kein entsprechender Gesell-
schafterbeschluss erforderlich sind).

Art. 10. Ausgleichszahlung für den Rückkauf.
10.1 Der Rückkauf erfolgt gegen eine Ausgleichszahlung.
10.2 Die Ausgleichszahlung besteht aus einem Gesamtbetrag, welcher dem Marktwert der zurückgekauften Anteile

entspricht. Als Stichtag gilt der Tag vor dem Rückkaufsbeschluss.

10.3 Die Ausgleichszahlung für den Rückkauf ist unmittelbar mit dem Rückkauf der Anteile fällig und zahlbar.
10.4 Der ausscheidende Gesellschafter ist nicht dazu befugt, von der Gesellschaft Sicherheiten für ausstehende Beträge

zuzüglich Zinsen zu verlangen.

10.5 Bei Streitigkeiten hinsichtlich des Betrags der zu zahlenden Ausgleichszahlung für den Rückkauf ist diese Aus-

gleichszahlung von einem Wirtschaftsprüfer in der Eigenschaft als Schiedsgutachter, der von den Gesellschaftern gemein-
schaftlich ernannt wird, festzulegen. Wird über die Ernennung des Schiedsgutachters keine Einigung erzielt, so wird dieser
auf Ersuchen eines Gesellschafters oder der Gesellschaft vom Vorsitzenden des Bezirksgerichts (Tribunal d’Arrondisse-
ment) bestimmt. Die Entscheidung des Schiedsgutachters ist bindend. Die Kosten für das Gutachten werden von der
Gesellschaft und dem betreffenden Gesellschafter zu gleichen Teilen getragen, wobei der vom Gesellschafter zu tragende
Teil mit der Ausgleichszahlung für den Rückkauf verrechnet und die Ausgleichszahlung für den Rückkauf dementsprechend
herabgesetzt wird. Der Gesellschafter hat die übrigen Kosten zu tragen, sofern die Ausgleichszahlung für den Rückkauf
die dem Gesellschafter zugewiesenen Kosten für das Gutachten nicht deckt.

Art. 11. Abtretung anstelle von Rückkauf.
11.1 Die Gesellschaft kann entscheiden, dass der betreffende Gesellschafter anstelle des Rückkaufs die Anteile an eine

von der Gesellschaft benannte Person (einschließlich eines anderen Gesellschafters) zu übertragen hat, auch im Falle eines
Teilrückkaufs oder einer Teilabtretung der Anteile an die Gesellschaft oder an eine von der Gesellschaft benannte Person.

11.2 Der vorliegende Artikel 11 gilt mit der Maßgabe, dass, wie in Artikel 10 dieser Satzung vorgesehen, die Aus-

gleichszahlung  für  die  abzutretenden  Anteile  durch  die  die  Anteile  erwerbende  Person  geschuldet  ist  und  dass  die
Gesellschaft als Garant haftet.

C. Entscheidungen der Gesellschafter

Art. 12. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
12.1 Die Gesellschafterversammlung ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch das Gesetz und diese Satzung

ausdrücklich vorbehalten sind.

12.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.
12.3  Falls  und  solange  die  Gesellschaft  nicht  mehr  als  fünfundzwanzig  (25)  Gesellschafter  hat,  dürfen  gemeinsame

Entscheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung vorbehalten wären, schriftlich gefasst werden. In die-
sem Fall erhält jeder Gesellschafter den Text der zu fassenden Beschlüsse oder Entscheidungen in ausformulierter Form
und übt sein Stimmrecht schriftlich aus.

12.4 Gesellschafterbeschlüsse werden in Versammlungen gefasst. Sofern nicht zwingende gesetzliche Vorschriften eine

andere Form vorschreiben, können sie auch außerhalb von Versammlungen in schriftlicher Form (einschließlich E-Mail
oder Fax) oder durch telefonische Abstimmung gefasst werden, sofern ein solches Verfahren von einem Gesellschafter
ersucht wird und kein anderer Gesellschafter innerhalb von zwei (2) Wochen in schriftlicher Form Widerspruch gegen

126230

L

U X E M B O U R G

dieses Verfahren gegenüber dem Rat der Geschäftsführer der Gesellschaft einlegt. Wird innerhalb von zwei (2) Wochen
kein Widerspruch gemäß des vorstehenden Satzes eingelegt, so werden die Stimmen der nicht an der Abstimmung teil-
nehmenden Gesellschafter als Enthaltungen gewertet. Schriftliche Beschlüsse sind von jedem Gesellschafter zu unter-
zeichnen und die Niederschrift ist jedem Gesellschafter unverzüglich zuzusenden. Beschlüsse, welche nicht in schriftlicher
Form gefasst werden, sind schriftlich zu bestätigen. Eine solche Bestätigung hat ausschließlich feststellende Bedeutung.

12.5 Von jedem Beschluss, der in Gesellschafterversammlungen gefasst wurde, ist unverzüglich eine Niederschrift

anzufertigen (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die Wirksamkeit), die das Datum und die Form des gefassten
Beschlusses, den Inhalt des Beschlusses und die abgegebenen Stimmen zu enthalten hat, es sei denn, die Gesellschafter-
beschlüsse wurden notariell beurkundet. Die Niederschrift muss jedem Gesellschafter unverzüglich in schriftlicher Form
zugesendet werden.

12.6 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschriften

des Abschnitts XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jede Bezugnahme auf die „Gesell-
schafterversammlung“ in der vorliegenden Satzung als Bezugnahme auf den Alleingesellschafter, je nach Zusammenhang
und soweit anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingesellschafter
ausgeübt.

Art. 13. Gesellschafterversammlung.
13.1 Gesellschafterversammlungen finden am Sitz der Gesellschaft oder an einem Ort und zu einer Zeit statt, welche

in der entsprechenden Einladung genauer bestimmt werden.

13.2  Die  Gesellschafterversammlung  wird  mittels  Einschreiben  (Zustellung  zu  eigenen  Händen,  Einschreiben  oder

Einschreiben mit Rückschein) an jeden Gesellschafter einberufen und beinhaltet den Ort, das Datum, die Uhrzeit und die
Tagesordnung,  wobei  bei  ordentlichen  Gesellschafterversammlungen  eine  Ankündigungsfrist  von  mindestens  vier  (4)
Wochen und bei außerordentlichen Gesellschafterversammlungen eine Ankündigungsfrist von mindestens zwei (2) Wo-
chen einzuhalten ist. Die Ankündigungsfrist beginnt am Tag nach dem Versand. Der Tag der Gesellschafterversammlung
wird bei der Berechnung der Ankündigungsfrist nicht berücksichtigt.

13.3 Falls alle Gesellschafter in einer Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten sind und auf Einladungs-

formalitäten verzichtet haben, kann die Versammlung auch ohne vorherige Ankündigung abgehalten werden.

13.4  Jeder  Gesellschafter  ist  dazu  berechtigt,  bei  der  Gesellschafterversammlung  von  einem  anderen  durch  eine

schriftliche Vollmacht dazu berechtigten Gesellschafter oder von einem Anwalt, Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer
unter der Berufsverschwiegenheitspflicht begleitet oder vertreten zu werden.

13.5 Eine Niederschrift hinsichtlich des Ablaufs der Versammlung ist (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die

Wirksamkeit) anzufertigen und hat den Ort und das Datum der Versammlung, die Teilnehmer, die Tagesordnungspunkte,
den Hauptinhalt der Verhandlungen und die Gesellschafterbeschlüsse zu beinhalten, es sei denn, die Verhandlungen der
Gesellschafterversammlung wurden notariell beurkundet. Die Niederschrift ist von allen bei der Gesellschafterversamm-
lung  anwesenden  oder  vertretenen  Gesellschaftern  zu  unterzeichnen  (als  Nachweis,  nicht  als  Voraussetzung  für  die
Wirksamkeit). Jedem Gesellschafter ist eine Kopie der Niederschrift zuzusenden.

Art. 14. Quorum und Abstimmung.
14.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.
14.2 Eine Gesellschafterversammlung ist nur dann beschlussfähig, wenn mindestens fünfzig Prozent (50%) des Gesell-

schaftskapitals vertreten sind. Vorbehaltlich anderer Regelungen dieser Satzung oder des Gesetzes von 1915, die ein
höheres Mehrheitsverhältnis vorsehen, bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von
Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals innehaben. Bei Beschlussunfähigkeit ist unverzüglich im
Einklang mit Artikel 13.2 eine neue Gesellschafterversammlung mit derselben Tagesordnung einzuberufen. Diese Gesell-
schafterversammlung ist dann unabhängig von dem vertretenen Gesellschaftskapital beschlussfähig, sofern darauf in der
die Versammlung einberufenden Ladung hingewiesen wurde und Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen
Stimmen gefasst.

Art. 15. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.

Art. 16. Änderung der Satzung.  Eine  Änderung  dieser  Satzung  erfordert  die  Zustimmung  (i)  einer  zahlenmäßigen

Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die gleichzeitig eine Qualifizierte Mehrheit darstellen.

Art. 17. Beschlüsse, die eine spezifische Mehrheit erfordern.
17.1 Gesellschafterbeschlüsse hinsichtlich der folgenden Angelegenheiten erfordern eine Qualifizierte Mehrheit:
17.1.1 Abschluss von Unternehmensverträgen (im Sinne der §§ 291 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG));
17.1.2 Abschluss von Unternehmensbeteiligungen (um Zweifel auszuschließen, nicht durch die Veräußerung von An-

teilen) jeglicher Art einschließlich stiller Beteiligungen und sämtlicher Verträge, durch welche die andere Vertragspartei
eine Beteiligung am Gewinn der Gesellschaft erhält oder jede Zahlung, welche vom Gewinnbetrag der Gesellschaft ab-
hängig ist; dies umfasst nicht Verträge mit Gesellschaftern oder Angestellten der Gesellschaft, einschließlich Verträge,
welche im Hinblick auf einen voraussichtlichen Status als Gesellschafter oder Angestellter abgeschlossen wurden, sowie

126231

L

U X E M B O U R G

Verträge mit Dritten innerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs, z.B. Verträge zwischen der Gesellschaft und Werbe-
partnern.

17.2 Beschlüsse hinsichtlich der folgenden Angelegenheiten erfordern eine Qualifizierte Mehrheit und zudem die vor-

herige Zustimmung der Investoren:

17.2.1 Wesentliche Änderungen des Geschäftszwecks der Gesellschaft;
17.2.2 Änderungen dieser Satzung;
17.2.3 Ausschluss von Bezugsrechten im Falle von Kapitalerhöhungen;
17.2.4 Erwerb eigener Anteile der Gesellschaft, mit Ausnahme der Erwerbe gemäß Artikel 9.2 und Übertragungen

gemäß Artikel 11.1 dieser Satzung;

17.2.5 Veräußerung des gesamten Gesellschaftsvermögens oder eines beträchtlichen Anteils des Gesellschaftsvermö-

gens einschließlich des Beschlusses hinsichtlich der Liquidation der Gesellschaft;

17.2.6 Verschmelzung, Ausgliederung und Umwandlung der Gesellschaft.
17.3  Ist  das  Gesellschaftskapital  in  verschiedene  Anteilsklassen  unterteilt,  so  können  die  spezifischen  Rechte  und

Pflichten im Zusammenhang mit einer Anteilsklasse mit der einstimmigen und schriftlichen Zustimmung der Gesellschaf-
ter, die alle ausgegebenen Anteile dieser Anteilsklasse halten, verändert oder aufgehoben werden.

D. Rat der Geschäftsführer

Art. 18. Befugnisse des Alleinigen Geschäftsführers - Zusammensetzung und Befugnisse des Rates der Geschäftsführer.
18.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Ge-

schäftsführer hat, bilden diese einen Rat der Geschäftsführer.

18.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „alleiniger Ge-

schäftsführer“ nicht ausdrücklich in dieser Satzung verwendet wird, ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Rat der
Geschäftsführer“ als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer“ auszulegen.

18.3 Der Rat der Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, im Namen der Gesellschaft zu handeln

und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.

Art. 19. Ernennung, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
19.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung ernannt, welche ihre Bezüge und

ihre Amtszeit festlegt.

19.2 Die Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund ernannt oder abberufen werden.
19.3 Die Gesellschafterversammlung kann die Ernennung von Geschäftsführern zwei (2) unterschiedlicher Kategorien

beschließen, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Eine solche Klassifizierung
der Geschäftsführer muss ordnungsgemäß in der Niederschrift des betreffenden Gesellschafterbeschlusses festgehalten
und die Geschäftsführer der Kategorie, der sie angehören, zugeordnet werden.

Art. 20. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
20.1  Scheidet  ein  Geschäftsführer  durch  Tod,  Geschäftsunfähigkeit,  Insolvenz,  Rücktritt  oder  aus  einem  anderem

Grund aus seinem Amt aus, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen
die ursprüngliche Amtszeit des ersetzten Geschäftsführers nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesell-
schafterversammlung ausgefüllt werden, welche im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die
endgültige Ernennung entscheidet.

20.2  Für  den Fall, dass der alleinige  Geschäftsführer aus  seinem Amt ausscheidet,  muss  die frei gewordene Stelle

unverzüglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.

Art. 21. Einladung zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
21.1 Der Rat der Geschäftsführer versammelt sich auf Einberufung durch einen Geschäftsführer. Die Sitzungen des

Rates der Geschäftsführer finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.

21.2  Die  Geschäftsführer  werden  mindestens  vierundzwanzig  (24)  Stunden  vor  dem  für  die  Sitzung  anberaumten

Zeitpunkt zu jeder Sitzung des Rates der Geschäftsführer schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe
der Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Geschäftsführer
per Post, Fax, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abgegeben haben, wobei
eine Kopie eines solchen Dokuments ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung zu Sitzungen des Rates der Ge-
schäftsführer ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss des Rates der Geschäftsführer
bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.

21.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle

Einladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Rates
der Geschäftsführer diesen zustimmen und diese unterzeichnen.

126232

L

U X E M B O U R G

Art. 22. Geschäftsführung.
22.1 Der Rat der Geschäftsführer kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Rat der Ge-

schäftsführer kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise selbst ein Geschäftsführer sein muss
und der für die Protokollführung der Sitzungen des Rates der Geschäftsführer verantwortlich ist.

22.2 Sitzungen des Rates der Geschäftsführer werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Rates der Ge-

schäftsführer geleitet. In dessen Abwesenheit kann der Rat der Geschäftsführer einen anderen Geschäftsführer durch
einen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Mitglieder als Vorsitzenden pro tempore ernennen.

22.3 Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer teilnehmen, indem er einen anderen

Geschäftsführer schriftlich oder durch Faxschreiben, per E-Mail oder durch ein anderes vergleichbares Kommunikati-
onsmittel bevollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Geschäftsführer
kann einen oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.

22.4 Eine Sitzung des Rates der Geschäftsführer kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein

anderes Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu
hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel
ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung gilt als am Sitz der Ge-
sellschaft abgehalten.

22.5 Der Rat der Geschäftsführer kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest eine Mehrheit der

Geschäftsführer in einer Sitzung anwesend oder vertreten ist.

22.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Rates der Geschäftsführer

teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden,
hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme. Sofern die Gesellschafterversammlung allerdings un-
terschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäfts-
führer der Kategorie B), werden Beschlüsse des Rates der Geschäftsführer nur dann wirksam gefasst, wenn sie von der
Mehrheit der Geschäftsführer einschließlich mindestens eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsfüh-
rers der Kategorie B (oder deren Vertreter) gefasst werden.

22.7 Der Rat der Geschäftsführer kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung,

per Faxschreiben, oder per E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Jeder Geschäftsführer
kann  seine  Zustimmung  getrennt  erteilen,  wobei  die  Gesamtheit  aller  schriftlichen  Zustimmungen  die  Annahme  des
betreffenden Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Be-
schlusses.

22.8 Die Geschäftsführer benötigen die Zustimmung eines oder mehrerer Gesellschafter, die gemeinsam mehr als

fünfzig Prozent (50%) des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft halten (die „Einfache Mehrheit“) für die unten genannten
Rechtsgeschäfte und Maßnahmen. Eine Zustimmung ist nicht erforderlich, sofern solche Rechtsgeschäfte und Maßnahmen
präzise definiert und im Voraus von einem bewilligten Haushaltsplan mit einer Einfachen Mehrheit genehmigt wurden:

22.8.1 Gründung, Erwerb, Schließung oder Veräußerung von Unternehmen oder Teilbetrieben;
22.8.2 Änderung der Statuten, dieser Satzung, Gesellschaftervereinbarungen und ähnlicher Verträge, sowie die Aus-

übung (oder der Ausschluss) von Gesellschafterrechten bei Gesellschaften, in denen eine Beteiligung gehalten wird;

22.8.3 Erwerb, Verkauf und Belastung von Immobilien und ähnlichen Rechten oder Rechten an Immobilien;
22.8.4 Gründung, Verlegung und Schließung von Filialen und Niederlassungen;
22.8.5 Änderung der Geschäftsfelder der Gesellschaft und Aufgabe bestehender und Aufnahme neuer Geschäftsfelder;
22.8.6 Genehmigung des Jahresplans, insbesondere des Haushaltsplans für jedes folgende Jahr;
22.8.7 Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder ähnlichen Verpflichtungen, die einen Gesamtbetrag von zwei-

hunderttausend Euro (EUR 200.000,00) überschreiten;

22.8.8  Gewährung  von  Darlehen,  die,  im  Einzelfall,  einen  Betrag  von  zweihunderttausend  Euro  (EUR  200.000,00)

überschreiten, allerdings unter Ausschluss von Darlehen zwischen der Gesellschaft und direkten und indirekten Toch-
tergesellschaften der Gesellschaft;

22.8.9 Abschluss und Kündigung von Kredit- und Darlehensverträgen und anderen Finanzverträgen, die, im Einzelfall,

einen Betrag von zweihunderttausend Euro (EUR 200.000,00) überschreiten und Änderungen des Kreditrahmens und
außerordentliche Rückzahlungen, allerdings unter Ausschluss von Verträgen zwischen der Gesellschaft und direkten und
indirekten Tochtergesellschaften der Gesellschaft;

22.8.10 Termingeschäfte über Devisen, Sicherheiten und börsengehandelte Waren und Rechte, sowie weitere Trans-

aktionen mit derivaten Finanzinstrumenten;

22.8.11 Gewährung, Einführung und Änderung von Versorgungsverpflichtungen jeglicher Art;
22.8.12 Abschluss, Änderung und Auflösung von Arbeitsverträgen, die eine Vergütung von einhundertfünfzigtausend

Euro (EUR 150.000,00) pro Jahr überschreiten;

22.8.13 Zusicherung oder Gewährung von Sonderzulagen und Gratifikationen jeglicher Art außerhalb bestehender

Arbeitsverträge, sowie Zahlung von Vorschüssen oder Gewährung von Darlehen an Geschäftsführer und Angestellte,
die, im Einzelfall, einen Betrag von fünfzigtausend Euro (EUR 50.000,00) überschreiten;

126233

L

U X E M B O U R G

22.8.14 Abschluss, Änderung oder Kündigung von Unternehmenstarifverträgen, Betriebsvereinbarungen (von erheb-

licher Bedeutung) und allgemeiner Richtlinien hinsichtlich der betrieblichen Altersvorsorge der Gesellschaft;

22.8.15 Einleitung oder Beendigung von Rechtsstreitigkeiten, insbesondere Schiedsgerichtverfahren mit einem Streit-

wert von über zehntausend Euro (EUR 10.000,00) im Einzelfall;

22.8.16 Erwerb, Verfügung und/oder Lizenzierung von Nutzungsrechten jeglicher Art hinsichtlich der Rechte an geist-

igem Eigentum, einschließlich Urheberrechte oder sämtliche weiteren Schutzrechte, sowie die Weitergabe von Know-
how zur eigenen Verwertung durch die Firma und/oder eine Drittpartei, sowie die Erteilung oder der Erwerb von Lizenzen
und die Abänderung diesbezüglicher Verträge, jedoch unter Ausschluss von Verfügungen zwischen der Gesellschaft und
direkten und indirekten Tochtergesellschaften der Gesellschaft;

22.8.17 Erteilung einer Vollmacht, durch welche ein Bevollmächtigter einen anderen Bevollmächtigten dazu ermächtigt,

auf Kosten der Gesellschaft einen Vertrag mit diesem zu schließen;

22.8.18 Transaktionen der Gesellschaft und ihrer Investoren mit verbundenen juristischen und natürlichen Personen.

Als  solche  werden  angesehen  direkte  oder  indirekte  Gesellschafter  der  Gesellschaft  (einschließlich,  zur  Klarstellung,
European Founders Fund GmbH („EFF“) und EFF’s direkte und indirekte Gesellschafter (z.B. die Samwer Brüder), aber
ausschließlich direkter oder indirekter Gesellschafter von ES, Aismare und/oder Eiffel), verbundene Gesellschaften gemäß
§§ 15 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG), sowie Angehörige direkter oder indirekter Gesellschafter gemäß Abschnitt
15 der deutschen Abgabenordnung (AO), sofern letztere (mit Ausnahme von EFF und EFF’s direkter und indirekter
Gesellschafter) - einzeln oder gemeinsam - direkt oder indirekt eine Mehrheitsbeteiligung halten. Die Zustimmung gemäß
dieses Artikels 22.8.18 ist nicht erforderlich, wenn die Transaktion zum gewöhnlichen Geschäftsgang der Gesellschaft
gehört und marktüblichen Bedingungen unterliegt;

22.8.19 Änderung der Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft;
22.8.20 Gewährung, Schaffung oder Änderung eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms (einschließlich der Gewährung

jeglicher Aktienoptionen) außerhalb der bestehenden vereinfachten Mitarbeiterbeteiligung, die zwischen den Gesellschaf-
tern in einer Gesellschaftervereinbarung vereinbart wurde;

22.8.21 Ausübung von Stimmrechten und anderen Rechten in einer Gesellschaft, deren Gesellschafter die Gesellschaft

ist, sofern diese Ausübung, wenn die Gesellschaft betroffen wäre, die Zustimmung der Einfachen Mehrheit nach dieser
Satzung erfordern würde, d.h. gemäß dieses Artikels 22.8 oder Artikels 17.

22.9 Ist die Zustimmung zum Erwerb, zum Verkauf oder zur Belastung von Objekten wie oben beschrieben erforder-

lich, so ist die Zustimmung ebenfalls für die damit verbundenen vertraglichen Verpflichtungen erforderlich. Die Gesell-
schafterversammlung kann durch einen Beschluss weitere Transaktionen und Maßnahmen bestimmen, die die Zustimmung
einer Einfachen Mehrheit erfordern. Die Einfache Mehrheit kann ihre Zustimmung für bestimmte Gruppen und Arten
von Transaktionen und Maßnahmen auch im Voraus erteilen.

22.10 Die Gesellschafter können durch einen Gesellschafterbeschluss eine Geschäftsordnung für die Geschäftsführer

beschließen.

22.11 Die Geschäftsführung hat sicherzustellen, dass die Bestimmungen dieses Artikels 22, soweit gesetzlich möglich,

auf die gleiche Weise auf sämtliche verbundenen Gesellschaften angewendet werden, in welchen die Gesellschaft direkt
oder indirekt gegenwärtig oder künftig eine Mehrheitsbeteiligung hält.

Art. 23. Protokoll von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer; Protokoll der Entscheidungen des Alleinigen Ge-

schäftsführers.

23.1 Das Protokoll einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer wird vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer,

falls vorhanden oder, im Falle seiner Abwesenheit, vom Vorsitzenden pro tempore und dem Schriftführer (falls vorhan-
den), oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unterschied-
liche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der
Kategorie B), werden Protokolle von einem (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einem (1) Geschäftsführer der
Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsver-
fahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer, falls
vorhanden, oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden solche Kopien oder Auszüge von einem (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einem (1)
Geschäftsführer der Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet.

23.2 Die Entscheidungen des alleinigen Geschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom alleinigen

Geschäftsführer unterzeichnet wird. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet.

Art. 24. Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Um-

ständen  (i)  durch  die  Unterschrift  des  alleinigen  Geschäftsführers  oder,  für  den  Fall,  dass  die  Gesellschaft  mehrere
Geschäftsführer hat, durch die gemeinsamen Unterschriften zwei (2) beliebiger Geschäftsführer wirksam verpflichtet;
sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäfts-
führer  der  Kategorie  A  und  Geschäftsführer  der  Kategorie  B),  wird  die  Gesellschaft  nur  durch  die  gemeinsamen
Unterschriften mindestens eines (1) Geschäftsführers der Kategorie A und eines (1) Geschäftsführers der Kategorie B

126234

L

U X E M B O U R G

(oder deren Vertreter), oder (ii) durch die gemeinsamen Unterschriften oder die alleinige Unterschrift jedweder Person
(en), der/denen eine Unterschriftsbefugnis durch den Rat der Geschäftsführer übertragen worden ist, wirksam verpflich-
tet.

Art. 25. Beirat.
25.1 Die Gesellschaft hat einen Beirat. Dieser besteht aus vier (4) stimmberechtigten Mitgliedern. Die Gesellschafter-

versammlung kann durch einen einstimmigen Gesellschafterbeschluss die Anzahl der stimmberechtigten Mitglieder des
Beirats erhöhen oder herabsetzen.

25.2 Die Gesellschafterversammlung kann die Geschäftsordnung für den Beirat nur durch einen einstimmigen Gesell-

schafterbeschluss festlegen und/oder verändern.

25.3 Die stimmberechtigten Mitglieder des Beirats werden von dem ernennenden Gesellschafter jedes entsprechenden

Mitglieds durch schriftliche Mitteilung an die Gesellschaft wie folgt ernannt, abberufen oder ersetzt:

25.3.1 Drei (3) stimmberechtigte Mitglieder des Beirats werden von dem Gesellschafter Rocket (die „Rocket-Mitglie-

der“) nach eigenem Ermessen ernannt; und

25.3.2 Ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats wird von dem Gesellschafter Aismare nach eigenem Ermessen

ernannt.

25.4 Jeder Gesellschafter, der nicht zur Ernennung eines stimmberechtigten Mitglieds des Beirats gemäß Artikel 25.3

berechtigt ist, darf ein nichtstimmberechtigtes Mitglied des Beirats als Beobachter ernennen.

25.5 Der Beirat hat einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden. Ein Rocket-Mitglied ist der Vorsit-

zende des Beirats. Die Geschäftsordnung des Beirats hat weitere Bestimmungen, insbesondere hinsichtlich der Selbst-
organisation des Beirats, zu enthalten. Der Beirat fasst Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Der
Beirat hält regelmäßig Sitzungen ab, mindestens einmal pro Kalenderquartal.

25.6 Der Beirat ist für die Beratung der Geschäftsführer der Gesellschaft hinsichtlich Strategie und operativer Ange-

legenheiten,  sowie  weiterer  Angelegenheiten  von  erheblicher  Bedeutung  (einschließlich,  aber  nicht  beschränkt  auf
potentielle Börsengänge und auf die Absicht zur maßgeblichen Eigenkapitalund/ oder Fremdkapitalerhöhung) zuständig
und berät mit den Geschäftsführern über den Haushalt der Gesellschaft.

25.7 Der Beirat ist kein Aufsichtsrat im Sinne des Artikels 60bis-11 ff. des Gesetzes von 1915.

E. Aufsicht und Prüfung der Gesellschaft

Art. 26. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
26.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der

Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)). Die Gesellschafterversammlung
ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.

26.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
26.3 Die Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Recht der permanenten Überprüfung und Kontrolle aller Ge-

schäfte der Gesellschaft.

26.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember

2002  betreffend  das  Handelsregister  und  die  Buchhaltung  und  den  Jahresabschluss  von  Unternehmen,  in  der  jeweils
gültigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d’entreprises agréé(s)) ernennen, entfällt
die Funktion des Rechnungsprüfers.

26.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die

Gesellschafterversammlung abberufen werden.

F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinnverwendung - Abschlagsdividenden

Art. 27. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am

einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

Art. 28. Jahresabschluss und Gewinne.
28.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Rat der Geschäftsführer erstellt im

Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und
Verlustrechnung.

28.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage

der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.

28.3  Durch  einen  Gesellschafter  erbrachte  Einlagen  in  Rücklagen  können  mit  Zustimmung  dieses  Gesellschafters

ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.

28.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage der Gesellschaft verhältnis-

mäßig herabgesetzt werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.

126235

L

U X E M B O U R G

28.5 Auf Vorschlag des Rates der Geschäftsführer bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den Be-

stimmungen des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung, wie der verbleibende jährliche Nettogewinn der Gesellschaft
verwendet werden soll.

28.6 Vorbehaltlich des Artikels 8 erfolgen Ausschüttungen an die Gesellschafter proportional zur Anzahl der von ihnen

an der Gesellschaft gehaltenen Anteile.

Art. 29. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
29.1 Der Rat der Geschäftsführer kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche

vom Rat der Geschäftsführer vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur
Verfügung stehen. Der ausschüttbare Betrag wird gegebenenfalls verteilt und darf nicht die Summe der seit dem Ende
des vergangenen Geschäftsjahres angefallenen Gewinne, gegebenenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne und aus-
schüttbare  Rücklagen,  beziehungsweise  vermindert  durch  vorgetragene  Verluste  und  Summen,  die  einer  Rücklage
zugeführt werden, welche nach dem Gesetz von 1915 oder dieser Satzung nicht ausgeschüttet werden darf, übersteigen.

29.2 Das Agio, andere Kapitalreserven oder andere ausschüttbare Rücklagen können im Einklang mit den Bestimmun-

gen des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

G. Liquidation

Art. 30. Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Liqui-

dation durch einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden,
die über die Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit
nichts anderes bestimmt wird, haben die Liquidatoren die weitestgehenden Befugnisse für die Verwertung der Vermö-
genswerte und die Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

H. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht

Art. 31. Anwendbares Recht.
31.1 Sämtliche in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten unterliegen den Bestimmungen des Gesetzes von

1915 und jeder Gesellschaftervereinbarung, die die Gesellschafter mitunter mit der Gesellschaft eingehen und durch die
bestimmte Bestimmungen dieser Satzung ergänzt werden könnten. Sollte ein Artikel dieser Satzung mit den Bestimmungen
einer Gesellschaftervereinbarung in Widerspruch stehen, so ist die Gesellschaftervereinbarung zwischen den Parteien,
soweit nach luxemburgischem Recht zulässig, maßgebend.

31.2 Diese Satzung wurde auf Englisch verfasst, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; im Falle von Abweichungen

zwischen der englischen und der deutschen Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.“

6. Verschiedenes.
Nach ordnungsgemäßer Prüfung jedes Tagesordnungspunkts fasst die Gesellschafterversammlung einstimmig die fol-

genden Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, zwei (2) Anteilsklassen im Gesellschaftskapital der Gesellschaft zu schaffen,

sodass die Gesellschaft nunmehr zwei (2) Anteilsklassen hat, bestehend aus Stammanteilen (die „Stammanteile“) und
Anteilen der Serie A (die „Anteile der Serie A“) und die bestehenden zwölftausendfünfhundert (12.500) Anteile mit einem
Nominalwert von je einem Euro (EUR 1) ohne Einziehung von Anteilen in zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteile
mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1) umzuwandeln.

<i>Zweiter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung nimmt (i) Netris B.V., (ii) Aismare Lux Holdings S.à r.l. und (iii) JP Ventures UG (haf-

tungsbeschränkt), vorbenannt, als neue Gesellschafter der Gesellschaft an.

<i>Dritter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, das Gesellschaftskapital der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von

zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) um einen Betrag von eintausendsiebenhundertneun Euro (EUR 1.709) auf
einen Betrag von vierzehntausendzweihundertneun Euro (EUR 14.209) durch die Ausgabe von eintausendsiebenhun-
dertneun (1.709) Anteilen der Serie A mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1), zu erhöhen.

<i>Zeichnung

Die eintausendsiebenhundertneun (1.709) Anteile der Serie A wurden ordnungsgemäß wie folgt gezeichnet:
- vierhundertsiebzehn (417) Anteile der Serie A wurden von Eiffel, vorbenannt, hier vertreten wie vorerwähnt, zu

einem Preis von vierhundertsiebzehn Euro (EUR 417) gezeichnet;

- eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Anteile der Serie A wurden von Aismare, vorbenannt, hier vertreten wie vor-

erwähnt, zu einem Preis von eintausendzweihundertfünfzig Euro (EUR 1.250) gezeichnet;

- zweiundvierzig (42) Anteile der Serie A wurden von ES, vorbenannt, hier vertreten wie vorerwähnt, zu einem Preis

von zweiundvierzig Euro (EUR 42) gezeichnet.

126236

L

U X E M B O U R G

<i>Zahlung

Die von Eiffel, Aismare und ES, vorbenannt, gezeichneten eintausendsiebenhundertneun (1.709) Anteile der Serie A

wurden vollständig eingezahlt durch eine Bareinlage in Höhe von eintausendsiebenhundertneun Euro (EUR 1.709).

Die Summe von eintausendsiebenhundertneun Euro (EUR 1.709) steht der Gesellschaft ab sofort zur freien Verfügung,

so wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde.

Die Einlage in Höhe von eintausendsiebenhundertneun Euro (EUR 1.709) wird vollständig dem Gesellschaftskapital

zugeführt.

<i>Vierter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, Artikel fünf Punkt eins (5.1) der Satzung der Gesellschaft zu ändern, welcher

nunmehr wie folgt lautet:

„ Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt vierzehntausendzweihundertneun Euro (EUR 14.209,00), beste-

hend aus

5.1.1  zwölftausendfünfhundert  (12.500)  Stammanteilen  mit  einem  Nominalwert  von  je  einem  Euro  (EUR  1)  (die

„Stammanteile”), und

5.1.2 eintausendsiebenhundertneun (1.709) Anteilen der Serie A mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1)

(die „Anteile der Serie A“, die im Folgenden auch als „Vorzugsanteile“ bezeichnet werden).

Die mit den Anteilen verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es wird in dieser Satzung oder

durch das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.“

<i>Fünfter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, unter anderem infolge des Vorstehenden, einstimmig die gänzliche Neu-

fassung der Satzung der Gesellschaft, welche nunmehr wie in der Tagesordnung der vorliegenden Urkunde dargestellt
lautet.

Da die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung geschlossen.

<i>Kosten und Auslagen

Die Kosten, Auslagen, Honorare und Gebühren jeglicher Art, die von der Gesellschaft zu tragen sind, werden auf

ungefähr EUR 2.500,- geschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg am eingangs erwähnten Datum.
Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache beherrscht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende

Urkunde auf Verlangen der erschienenen Parteien auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung;
auf Verlangen besagter erschienener Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen
Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.

Die vorstehende Urkunde ist der Bevollmächtigten der erschienenen Parteien, welche dem Notar mit Namen, Vorn-

amen und Wohnsitz bekannt ist, verlesen und vom Notar gemeinsam mit dieser Bevollmächtigten unterzeichnet worden.

Gezeichnet: A. VAN DER WIELEN und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 18 juillet 2014. Relation: LAC/2014/33898. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

Für gleichlautende Ausfertigung zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

Luxemburg, den 15. September 2014.

Référence de publication: 2014144149/1309.
(140163883) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2014.

Spark Energy Solutions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 164.153.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 juillet 2014.

Référence de publication: 2014107966/10.
(140128254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2014.

126237

L

U X E M B O U R G

Tlux Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 105.278.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des Actionnaires qui aura lieu au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, le <i>9 octobre 2014 à 9.00 heures, en deuxième
convocation, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d'Administration et son approbation.
2. Lecture du rapport du Commissaire aux comptes.
3. Approbation des bilans, comptes de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2013.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire.
5. Divers.

Référence de publication: 2014145250/545/16.

CIGOGNE Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 101.547.

CIGOGNE MANAGEMENT S.A.

acting on behalf of STORK FUND - ALL COMPARTMENT

The Executive Board of Cigogne Management S.A. (the “Management Company”) convene the Unitholders of STORK

FUND (the “Fund”) at an extraordinary general meeting of Unitholders in order to deliberate on the transformation of
the Fund as a SICAV governed by the Luxembourg Law of 13 February 2007 on Specialized Investment Fund (the “2007
Law”) and also informed Unitholders of the prospectus amendments.

1. EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Unitholders are convened to an Extraordinary General Meeting to be held <i>October 8, 2014 at 11.00 a.m. (Luxembourg

time) at 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg, to deliberate at the following agenda:

<i>Agenda:

a. to approve, in accordance with article 70 of 2007 Law, the conversion of the Fund into a société d'investissement

à capital variable (“SICAV”) governed by chapter 3 of the 2007 Law, and the SICAV's name of “STORK FUND” (the
“Conversion”);

b. to fix the effective date (the “Effective Date”) of the Conversion;

c. to adopt the Articles of Incorporation of the SICAV in the form submitted to the Unitholders;

d. to fix the registered office of the SICAV at 9, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg;

e. to appoint the following persons as directors of the SICAV with effect from the Effective Date:

- Georges VANDERMARLIERE, Administrateur Délégué, Cigogne Management S.A.;
- Guillaume BINNENDIJK, Managing Director, Cigogne Management S.A.;
- Joffrey CZURDA, Managing Director, Cigogne Management S.A.;

f. to name Deloitte Audit S.à.r.l. as auditor of the SICAV for the accounting year ending on 31 December 2014.

Costs resulting from this transformation will be incurred by the Fund.
Items on the agenda of the extraordinary general meeting require no quorum; the resolution shall be validly adopted

with at least a majority of two-thirds of the votes of Unitholders present or represented regardless of the portion of the
capital represented. A Unit, regardless of denomination, is entitled to one vote.

Any Unitholder wishing to be present or represented at the Extraordinary General Meeting must notify Cigogne

Management S.A. before October 6, 2014.

Any Unitholder holding bearer shares, must also file its shares before October 6, 2014 at the registered office of

Cigogne Management S.A. Luxembourg, boulevard du Prince Henri 9, L-1724.

The draft text of the Articles of Incorporation is available without charge at the registered office of Cigogne Manage-

ment S.A. Luxembourg, boulevard du Prince Henri 9, L-1724.

Unitholders are informed that proxies are available at the registered office of Cigogne Management S.A. Luxembourg,

boulevard du Prince Henri 9, L-1724.

126238

L

U X E M B O U R G

2. AMENDMENTS OF THE PROSPECTUS

Subject to the transformation approval by the Extraordinary General Meeting of Unitholders, and except where the

Executive Board of the SICAV decides otherwise, shareholders of STORK FUND (the “Shareholders”) are advised that
the following changes are made to the Prospectus:

a. Amendments resulting from the transformation into a SICAV
The terms FCP or Fund, Unitholders, Units are respectively replaced by the SICAV terms, shareholders and shares.

The provisions relating to contracts signed by the Fund respectively by the Management Company are updated.

b. Removal of the following compartments
After an inactive period exceeding eighteen months, the following compartments are to be removed from the pros-

pectus of STORK FUND:

o STORK FUND - Absolute Performance;
o STORK FUND - Aggressive Profile;
o STORK FUND - Credit &amp; Bonds Arbitrage.

c. Harmonisation of cut-off time
The cut-off time for payments following a redemption are harmonize for all type of shares of STORK FUND.

d. Update of the regulation reference
Adapt STORK FUND Prospectus and Articles of Incorporation according to the Luxembourg Law of 12 July 2013 on

alternative investment fund managers.

CIGOGNE MANAGEMENT will be acting as the Alternative Investment Fund Manager (“AIFM”) of STORK FUND.
Regarding the amendments, the shareholders are cautioned to carefully read the entire Prospectus.
These modifications will come into effect on October 8, 2014.
The full Prospectus and the Articles of Incorporation dated October 8, 2014 will be available free of charge upon

request at the registered office of the SICAV and the Management Company office (9, boulevard du Prince Henri).

Shareholders who would not agree with these changes have the opportunity to request redemption of their shares

free of charge for a period of one month from the date of publication of this notice.

Référence de publication: 2014145258/755/64.

Point Blank Promotions S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 20.592.

Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Référence de publication: 2014109858/10.
(140130762) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2014.

Portlux, Société Anonyme.

Siège social: L-6688 Mertert, Port de Mertert.

R.C.S. Luxembourg B 6.966.

<i>Auszug aus der Ordentlichen Gesellschafterversammlung vom 22. Juli 2014:

Zum neuen Prüfungskommissar wird ernannt:
Grant Thornton Weber &amp; Bontemps, R.C.S. B 183690 mit Sitz in 6, place de Nancy, L-2212 Luxemburg Das Mandat

des Prüfungskommissars endet mit der ordentlichen Gesellschafterversammlung im Jahre 2020.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23. Juli 2014.

<i>Pour la société

Référence de publication: 2014109861/14.
(140130528) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2014.

126239

L

U X E M B O U R G

Haute Horlogerie Benelux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 96.159.

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de HAUTE HORLOGERIE BENELUX S.A., Société Anonyme de droit Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin, L-1746

Luxembourg, RCS de Luxembourg n° B 96.159

qui se tiendra le mercredi <i>8 octobre 2014 à 14.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2013 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs

titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014144557/755/20.

Henderson Horizon Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2530 Gasperich, 4A, rue Henri Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 22.847.

NOTICE is hereby given to the shareholders of Henderson Horizon Fund that the

ANNUAL GENERAL MEETING

of Henderson Horizon Fund will be held at its registered office at 2 Rue de Bitbourg L-1273 Luxembourg at 11 am

(Luxembourg time) on <i>9th October 2014 for the purpose of considering and voting upon the following matters:

<i>Agenda:

1. Approval of the Reports of the Directors and of the Independent Auditor on the annual accounts for the year

ended 30 June 2014.

2. Approval of the audited annual accounts at 30 June 2014.
3. Allocation of net results.
4. Distribution of dividends (if any) as recommended by the Directors.
5. Discharge of liabilities to the Directors for the exercise of their mandate.
6. Re-election of Les Aitkenhead, Iain Clark, Tony Sugrue, Jeremy Vickerstaff, Steven de Vries and Jean-Claude Wolter

to the Board of Directors

7. Approval of the replacement of Stewart Cazier by the Election (subject to CSSF Approval) of James Bowers.
8. Approval of the remuneration of the Independent Directors Iain Clark (as Chairman of the Board), Jean-Claude

Wolter and Les Aitkenhead (as Directors)

9. Election of PricewaterhouseCoopers, Société coopérative as the Independent Auditor of the Company in replace-

ment of KPMG, (subject to CSSF approval).

10. Miscellaneous.

Notes:
All shareholders are entitled to attend or be represented at the above Meeting. A shareholder is entitled to appoint

one or more proxies to attend and vote in his place. A proxy holder is not required to be a shareholder. To be valid,
Forms of Proxy must lodged at Henderson Horizon Fund, c/o Victor Buck Services S.A. - Client Services IVY Building,
Parc d'Activités, L-8308 Capellen, Grand Duchy of Luxembourg not less than 48 hours before the time appointed for the
Meeting.

The audited Annual Report and Accounts of the Company may be obtained from the registered office of Henderson

Horizon Fund, at the offices of the representatives and distributors and electronically at www.henderson.com.

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2014142547/34.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

126240


Document Outline

Algohal S.à r.l.

Alison Investments S.A.

Alma Consultancy S.A.

CIGOGNE Management S.A.

E.L.E. Lux S.A.

Emuto Global Capital S.à r.l.

F.P.T. Holding S.A.

Future Investments 2005 S.A.

Grel S.A.

Haute Horlogerie Benelux S.A.

Helpling Group Holding S.à r.l.

Henderson Horizon Fund

High Gate Holding S.A.

Lux-Protect Fund

LUX-Trading S.A.

Magma Capital

Maison Stemper

MALG S.A.

Mangrove III Management S.A.

Mangrove III Sub Investments S.à r.l.

Mangrove Russia I (S.C.A.), SICAR

Mediterranean Strategical Investments S.A.

MENA Joint Investment Fund S.C.A., SICAV-SIF

Meridiam Eastern Europe S.à r.l.

Meridiam Infra Invest Brownfield S.à r.l.

Méridiam Infrastructure Finance S.à r.l.

Midwest Lux S.A.

Morgan Stanley Derivative Products Global S.à r.l.

Muzinich European Private Debt Fund

Mythology European Real Estate Fund S.C.A.

Point Blank Promotions S.A.

Portlux

Quinta Greentech Investments S.à r.l.

Sablon S.A.

Sacma International Group S.A.

Saft Finance S.à r.l.

Sagra Holdings

Saint-Gobain Abrasives S.A.

Samba Luxco S.àr.l.

S.à r.l. BDPX

School 1 S.à r.l.

SciCan Luxembourg S.à r.l.

Sheet Anchor LuxHoldCo S.à r.l.

Sigla Luxembourg Holdings S.à r.l.

SIGNA R.E.C.P. Development "Tuchlauben" Beteiligung S. à r.l.

Signode Industrial Group Holdings Lux S.à r.l.

Silicon Motion Technology (Luxembourg) Limited

Skyline Investments S.A.

Sofinga S.A.

Spark Energy Solutions S.à r.l.

Stidia S.A.

SuDel Invest S.à r.l.

SwanCap GP, S.à r.l.

Thagol S.à r.l.

Thalia Alternative SICAV

Theia SICAV SIF

Tlux Participations S.A.