This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2628
27 septembre 2014
SOMMAIRE
ACE Fashion S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126140
ADVICE.INC S.à r.l. SPF . . . . . . . . . . . . . . . .
126141
Bärlu S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126132
Chapes Bâtiments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
126137
Chiapparo G.m.b.h. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126133
Distribution Automobiles Luxembourg S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126139
Eastern Bulk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126100
ECE Real Estate Partners S.à r.l. . . . . . . . .
126102
Ech Lux 2 (Heilbronn) S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
126100
ECommerce Holding II S.à r.l. . . . . . . . . . . .
126108
EDEL Capital S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126098
Emery S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126144
Eneris International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
126144
Eneris Poland S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126144
Entreprise de Transports Nello Bei-Qua-
glia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126099
Enuma Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126098
EOF Soparfi A S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126098
EOF Soparfi B S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126099
Epicerie Sylvie S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126098
EPI Highgate S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126098
EPISO 3 Luxembourg Holding S.à r.l. . . . .
126099
Erice S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126099
Ernst August Carree S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
126100
Euroamerican Finance S.A. . . . . . . . . . . . . .
126099
Family Affair S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126105
Farta V S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126105
FDM Investment Corporation Soparfi . . .
126105
FEC Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126103
Fegon International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
126101
Fertitrust S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126102
FFV SCSp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126142
FIB-Services Intellectual S.A. . . . . . . . . . . . .
126104
Finsevi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126100
Fissler A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126103
FL Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126100
Fontgrande S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126101
Forever S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126101
FPI LUX S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126103
Fusion Poland Holdco S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
126105
GASTRONOMICA LUXEMBOURG S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126102
Gazania Capital S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
126101
G.D.E. Finances S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126106
G.D.E. Finances S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126143
Geffco Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126102
Genesta Nordic Baltic Real Estate S.à r.l.,
SICAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126101
GIA Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126106
GJL Management (Lux) S.à r.l. . . . . . . . . . .
126106
G-Lab S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126104
GM Topco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126104
Goodman Princeton Holdings (Lux) S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126105
Goodyear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126102
Greiwels S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126103
GTCR Gridlock Holdings (Luxembourg)
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126103
Hosta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126106
Ice Midco Limited S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126104
Inesia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126104
IRACO, Comptoir d'Importations, Repré-
sentations et Agences . . . . . . . . . . . . . . . . .
126106
Sarasino Soparfi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126131
Société Européenne d'Expansion Immobi-
lière S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126107
Solanis S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126136
Weldiflex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126131
126097
L
U X E M B O U R G
EDEL Capital S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 109.013.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juillet 2014.
Référence de publication: 2014106572/10.
(140127137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.
EPI Highgate S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.411.700,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 119.061.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juillet 2014.
Référence de publication: 2014106581/10.
(140127703) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.
EOF Soparfi A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 105.073.
Les comptes consolidés de CBRE European Office Fund CV au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2014106579/13.
(140127609) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.
Epicerie Sylvie S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4818 Rodange, 15, avenue Dr Gaasch.
R.C.S. Luxembourg B 152.595.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014106583/9.
(140127549) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.
Enuma Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 7A, rue des Glacis.
R.C.S. Luxembourg B 176.441.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juillet 2014.
<i>Pour compte de Enuma Holding S.A.
i>Fiduplan S.A.
Référence de publication: 2014106578/12.
(140127616) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.
126098
L
U X E M B O U R G
EOF Soparfi B S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 2.841.400,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 105.072.
Les comptes consolidés de CBRE European Office Fund CV au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2014106580/13.
(140127608) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.
Entreprise de Transports Nello Bei-Quaglia, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4959 Bascharage, 7, Z.A. Op Zaemer.
R.C.S. Luxembourg B 15.667.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014106577/10.
(140127008) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.
EPISO 3 Luxembourg Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.590,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 173.174.
Les comptes annuels pour la période du 16 novembre 2012 (date de constitution) au 31 décembre 2013 ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juillet 2014.
Référence de publication: 2014106584/11.
(140127698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.
Erice S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 71.917.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014106589/9.
(140127221) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.
Euroamerican Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 139.304.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juillet 2014.
SG AUDIT SARL
Référence de publication: 2014106604/11.
(140127711) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.
126099
L
U X E M B O U R G
Ernst August Carree S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 2.649.400,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 130.430.
Les comptes consolidés de CBRE European Office Fund CV au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2014106559/13.
(140127606) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.
Eastern Bulk, Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 103.410.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014106567/9.
(140127411) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.
FL Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 151.065.
Le Bilan au 31.12.2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014106647/10.
(140127022) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.
Ech Lux 2 (Heilbronn) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.525,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 161.719.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juillet 2014.
Référence de publication: 2014106570/10.
(140127691) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.
Finsevi S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 58.811.
Les comptes au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FINSEVI S.A.
Louis VEGAS-PIERONI / Régis DONATI
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2014106645/12.
(140127175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.
126100
L
U X E M B O U R G
Fontgrande S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 65.531.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014106652/9.
(140127431) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.
Fegon International S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-8561 Schwebach, 1, Haaptstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 72.287.
Les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014106640/10.
(140127515) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.
Forever S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1319 Luxembourg, 91, rue Cents.
R.C.S. Luxembourg B 183.607.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATIONi>
Référence de publication: 2014106653/10.
(140126878) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.
Gazania Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 3A, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 178.018.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Stonehage Corporate Services Luxembourg S.A.
3A, Val Ste Croix
L-1371 Luxembourg
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2014106662/14.
(140127773) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.
Genesta Nordic Baltic Real Estate S.à r.l., SICAR, Société à responsabilité limitée sous la forme d'une
Société d'Investissement en Capital à Risque.
Capital social: EUR 15.000,00.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 50, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 127.050.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 juillet 2014.
Référence de publication: 2014106670/11.
(140127583) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.
126101
L
U X E M B O U R G
Fertitrust S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 22, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 11.025.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour FERTITRUST S.A.
i>Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.
Référence de publication: 2014106641/11.
(140128010) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.
Geffco Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 187.647.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juillet 2014.
Référence de publication: 2014106678/10.
(140127080) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.
ECE Real Estate Partners S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-5326 Contern, 17, rue Edmond Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 157.549.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juillet 2014.
Référence de publication: 2014106569/10.
(140127701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.
GASTRONOMICA LUXEMBOURG S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1741 Luxembourg, 83, rue de Hollerich.
R.C.S. Luxembourg B 168.793.
EXTRAIT
Il résulte de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 18 juin 2014 que:
Monsieur Gabriele CICCHITTI a été révoqué de sa fonction de gérant administratif.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2014106677/11.
(140128110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.
Goodyear, Société Anonyme.
Siège social: L-7740 Colmar-Berg, avenue Gordon Smith.
R.C.S. Luxembourg B 4.441.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Colmar-Berg, le 18 juillet 2014.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2014106689/12.
(140127052) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.
126102
L
U X E M B O U R G
Fissler A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 17.302.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014106646/10.
(140127203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.
FPI LUX S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1319 Luxembourg, 91, rue Cents.
R.C.S. Luxembourg B 157.642.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATIONi>
Référence de publication: 2014106654/10.
(140126877) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.
FEC Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 173.487.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société FEC Lux S.à r.li>
Référence de publication: 2014106639/10.
(140126891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.
Greiwels S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8059 Bertrange, Gréiwelshaff.
R.C.S. Luxembourg B 116.864.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014106694/10.
(140127216) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.
GTCR Gridlock Holdings (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 1.378.791,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 162.934.
EXTRAIT
En date du 17 juillet 2014, l'associé de la Société a approuvé la résolution suivante:
- La démission d'Alan Botfield, en tant que gérant de catégorie B de la Société, est acceptée avec effet au 11 juillet
2014.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 21 juillet 2014.
Référence de publication: 2014106698/14.
(140127642) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.
126103
L
U X E M B O U R G
Ice Midco Limited S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 181.174.
<i>Extrait des décisions prises par les associées en date du 27 juin 2014i>
Le mandat de réviseur d'entreprises agréé de PricewaterhouseCoopers a été renouvelé jusqu'à l'issue de l'assemblée
générale statutaire de 2015.
Luxembourg, le 22 juillet 2014.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour Ice Midco Limited S.A.
i>Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.
Référence de publication: 2014106739/14.
(140128040) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.
Inesia S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 66.931.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Coralie-Aurore Leray.
Référence de publication: 2014106760/10.
(140127596) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.
GM Topco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 166.009.
Les comptes annuels de la société GM Topco S.à r.l. au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014106686/10.
(140128034) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.
G-Lab S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 178.295.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2014106660/10.
(140127223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.
FIB-Services Intellectual S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8399 Windhof, 20, rue de l'Industrie.
R.C.S. Luxembourg B 138.217.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014106643/10.
(140127101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.
126104
L
U X E M B O U R G
Family Affair S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 3A, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 78.856.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 22/7/2014.
Stonehage Corporate Services Luxembourg S.A.
3A, Val Ste Croix
L-1371 Luxembourg
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2014106633/15.
(140128027) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.
Farta V S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 64.502.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Extrait sincère et conforme
FARTA V S.A.
Référence de publication: 2014106634/11.
(140127102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.
FDM Investment Corporation Soparfi, Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R.C.S. Luxembourg B 47.604.
Par la présente, je tiens à vous faire part de ma démission en tant qu'administrateur au sein de FDM Investment
Corporation Soparfi, SA en date de ce jour, le 07 juillet 2014.
Esch/Alzette, le 07 juillet 2014.
Jean-Baptiste GAUVAIN.
Référence de publication: 2014106636/10.
(140127922) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.
Fusion Poland Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 171.488.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014106632/9.
(140127074) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.
Goodman Princeton Holdings (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 153.622.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014106673/9.
(140128126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.
126105
L
U X E M B O U R G
G.D.E. Finances S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8041 Strassen, 65, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 185.439.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 68962 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014106658/10.
(140127973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.
GJL Management (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 125.000,00.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 136.987.
Le bilan au 28 février 2104 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014106683/9.
(140127975) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.
GIA Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 173.249.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juillet 2014.
Référence de publication: 2014106680/10.
(140127054) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.
Hosta, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 177.844.
<i>Extrait des décisions de l'associé unique de la Société adoptées par écrit le 21 juillet 2014i>
L'associé unique de la Société a pris acte de la démission avec effet immédiat de Joël Lacourte de sa fonction de gérant
de la Société et a décidé de nommer François de Mitry dont l'adresse se situe au 4, Pembroke Villas, W8 6PG, Londres,
Royaume-Uni, en tant que gérant de la Société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Hosta
Un mandatairei>
Référence de publication: 2014106713/15.
(140128094) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.
IRACO, Comptoir d'Importations, Représentations et Agences, Société Anonyme.
Siège social: L-1337 Luxembourg, rue de la Cimenterie.
R.C.S. Luxembourg B 6.026.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
IRACO SA Luxembourg
Référence de publication: 2014106780/10.
(140127107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.
126106
L
U X E M B O U R G
Société Européenne d'Expansion Immobilière S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1463 Luxembourg, 29, rue du Fort Elisabeth.
R.C.S. Luxembourg B 105.845.
L'an deux mille quatorze, le vingt-sept juin.
Pardevant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie:
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «SOCIETE EUROPEENE D’EXPANSION
IMMOBILIERE S.A.”, avec siège social à L-1463 Luxembourg, 29, rue du Fort Elisabeth, constituée suivant acte notarié en
date du 24 janvier 2005, publié le 24 mai 2005 au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 486 et dont les
statuts n’ont pas été modifiés depuis lors.
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Guy Decker, employé privé, demeurant professionnellement
à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Carlo Noël, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alfred Polomski, administrateur de sociétés, demeurant profession-
nellement à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Décision à prendre concernant la dissolution de la société.
2. Nomination de Monsieur Alfred POLOMSKI, administrateur de sociétés, né à Calonne-Ricouart (F) le 2 avril 1953,
demeurant professionnellement à L-1463 Luxembourg, 29, rue du Fort Elisabeth, comme liquidateur et détermination de
ses pouvoirs.
3. Nomination comme commissaire à la liquidation de Madame Annie SPINDLER, née VANDESTEENE, directeur de
société, née le 5 octobre 1953 à Armentières, France, demeurant à F-98000 Monaco, 9, bld du Tenao.
4. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne
varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
"ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.
III.- Que l’intégralité du capital social est présente ou représentée à la présente assemblée.
IV.- Qu’en conséquence la présente assemblée, réunissant la totalité du capital social, est régulièrement constituée et
peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société à compter de ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide la mise en liquidation de la société et de nommer comme liquidateur Monsieur Alfred POLOMSKI,
administrateur de sociétés, né à Calonne-Ricouart (F) le 2 avril 1953, demeurant professionnellement à L-1463 Luxem-
bourg, 29, rue du Fort Elisabeth.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés
commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée générale
dans les cas où elle est requise.
Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires
telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée nomme Madame Annie SPINDLER, née VANDESTEENE, directeur de société, née le 5 octobre 1953 à
Armentières, France, demeurant à F-98000 Monaco, 9, bld du Tenao, en qualité de commissaire à la liquidation, confor-
mément à l’article 151 de la loi de 1915 concernant les sociétés commerciales et lui confie la mission de faire rapport sur
la gestion du liquidateur.
126107
L
U X E M B O U R G
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
à raison de la présente est évalué à environ MILLE EUROS (1000.- EUR).
Plus rien n'étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau, connus du notaire par leurs noms, prénoms
usuels, états et demeures, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: G. Decker, C. Noël, A. Polomski, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 2 juillet 2014. Relation: LAC/2014/30519. Reçu douze euros (EUR 12,-).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): C. FRISING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juillet 2014.
Référence de publication: 2014106128/69.
(140126838) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2014.
ECommerce Holding II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1736 Luxembourg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 177.435.
STATUTES
In the year two thousand and fourteen, on the fourth day of July.
Before us, Maître Carlo WERSANDT, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
1. Global Fin Tech Holding S.à r.l. a limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing
under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
(Registre de Commerce et des Sociétés) under number B 184.665, having its registered office at 7, avenue J.P. Pescatore,
L-2324 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (hereinafter “Global Fin Tech Holding”),
being the holder of twelve thousand four hundred ninety-nine (12,499) common shares and five thousand two hundred
fifty (5,250) series A shares,
here represented by Mr. Luis AGUERRE ENRÍQUEZ, Doctor en Derecho, professionally residing in Luxembourg, by
virtue of a proxy, given in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg on 30 June 2014;
2. Bambino 53. V V UG (haftungsbeschränkt), a limited liability company (Unternehmergesellschaft (haftungsbes-
chränkt)) existing under the laws of Germany registered with the commercial register at the local court of Charlottenburg,
Germany, under no. HRB 126893 B, having its registered address at Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Germany (hereinafter
“Bambino 53. V V”),
being the holder of one (1) common share,
here represented by Mr. Luis AGUERRE ENRÍQUEZ, Doctor en Derecho, professionally residing in Luxembourg, by
virtue of a proxy, given in Berlin, Germany on 30 June 2014;
3. HV Holtzbrinck Ventures Fund V GmbH & Co. KG, a limited partnership (Kommanditgesellschaft) under the laws
of Germany with its statutory seat in Munich, Germany, registered with the commercial register (Handelsregister) at the
local court of Munich (Amtsgericht München), Germany, under no. HRA 98863, having its business address at Kaiserstraße
14b, 80801 Munich, Germany, represented by its general partner, HV Holtzbrinck Ventures Holding GmbH, a limited
liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) existing under the laws of Germany, registered with the com-
mercial register at the local court of Munich, Germany, under no. HRB 185098 B, having its registered address at
Kaiserstraße 14 b, 80801 Munich, Germany, (hereinafter “Holtzbrinck”),
being the holder of three thousand six hundred twenty-five (3,625) series A shares, eight hundred forty-four (844)
series B shares and eight hundred fifty-four (854) series C shares,
here represented by Mr. Luis AGUERRE ENRÍQUEZ, Doctor en Derecho, professionally residing in Luxembourg, by
virtue of a proxy, given in Munich, Germany, on 4 July 2014;
4. AI Lendico Holdings LLC, a limited liability company under the laws of Delaware, United States of America, registered
with the Secretary of State of the state of Delaware under registration number 5482207, with its statutory seat in 2711
Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, United States of America (hereinafter “Access”),
being the holder of three thousand six hundred twenty-five (3,625) series A shares, eight hundred forty-four (844)
series B shares, and eight hundred fifty-four (854) series C shares,
here represented by Mr. Luis AGUERRE ENRÍQUEZ, Doctor en Derecho, professionally residing in Luxembourg, by
virtue of a proxy, given in New York, United States of America on 30 June 2014;
126108
L
U X E M B O U R G
5. TJT (B) (Bermuda) Investment Company Ltd., a limited liability company under the laws of Bermuda with its statutory
seat in Hamilton, Bermuda, having its business address at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, Bermuda HM11
(hereinafter, “TJT”),
being the holder of four hundred (400) series C shares,
here represented by Mr. Luis AGUERRE ENRÍQUEZ, Doctor en Derecho, professionally residing in Luxembourg, by
virtue of a proxy, given in Bermuda, on 30 June 2014;
6. Mr. David W. Zalaznick, born in New York, United States of America, on 16 April 1954, professionally residing in
9 West 57
th
Street - 33
rd
Floor, New York, NY 10019, USA (hereinafter “DZ”),
being the holder of four hundred (400) series C shares,
here represented by Mr. Luis AGUERRE ENRÍQUEZ, Doctor en Derecho, professionally residing in Luxembourg, by
virtue of a proxy, given in New York, United States of America, on 30 June 2014; and
7. Aismare Lux Holdings S.à r.l. a limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing
under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register
(Registre de Commerce et des Sociétés) under number B 176.544, having its registered office at 6C, rue Gabriel Lippmann,
L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg (hereinafter “Aismare”),
becoming the holder of eight hundred (800) series C shares and participating for item 3 of the agenda,
here represented by Mr. Luis AGUERRE ENRÍQUEZ, Doctor en Derecho, professionally residing in Luxembourg, by
virtue of a proxy, given in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg on 1 July 2014.
The said proxies, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary will remain annexed
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The parties listed under 1. to 6. (the “Existing Shareholders”) are all the shareholders, representing the entire share
capital of ECommerce Holding II S.à r.l. (the “Company”), a société à responsabilité limitée incorporated and existing
under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg,
Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 177.435
and incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on 7 May 2013, published in the Memorial C, Recueil
des Sociétés et Associations number 1651 dated 10 July 2013. The articles have been amended for the last time by deed
of the undersigned notary on 20 June 2014, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
The articles of association have not been amended since.
The Existing Shareholders representing the entire share capital declare having waived any notice requirement, the
general meeting of shareholders is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the following agenda
whereby Aismare participates and votes for the purpose of item 3 of the following Agenda only:
<i>Agendai>
1. Acceptance of Aismare Lux Holdings S.à r.l. a limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated
and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’
Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under number B 176.544, having its registered office at 6C, rue Gabriel
Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, as new shareholder of the Company.
2. Increase of the Company’s share capital by an amount of eight hundred euro (EUR 800) so as to raise it from its
current amount of twenty-nine thousand one hundred ninety-six euro (EUR 29,196) up to twenty-nine thousand nine
hundred ninetysix euro (EUR 29,996) by issuing eight hundred (800) Series C Shares with a nominal value of one euro
(EUR 1) each.
3. Amendment and full restatement of the articles of association of the Company.
Having duly considered each item of the agenda, the general meeting of shareholders unanimously takes the following
resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting of shareholders accepts Aismare Lux Holdings S.à r.l. a limited liability company (société à res-
ponsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the
Luxembourg Trade and Companies’ Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under number B 176.544, having
its registered office at 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, as new shareholder
of the Company.
<i>Second resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves to increase the share capital of the Company by an amount of eight
hundred euro (EUR 800) so as to raise it from its current amount of twenty-nine thousand one hundred ninety-six euro
(EUR 29,196) up to twenty-nine thousand nine hundred ninety-six euro (EUR 29,996) by issuing eight hundred (800)
Series C Shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.
126109
L
U X E M B O U R G
<i>Subscriptioni>
The eight hundred (800) new Series C Shares have been duly subscribed by Aismare aforementioned, for the price of
eight hundred euro (EUR 800).
<i>Paymenti>
The eight hundred (800) Series C Shares subscribed by Aismare, aforementioned, have been entirely paid up through
a contribution in cash in an amount of eight hundred euro (EUR 800).
The proof of the existence and of the value of the above contribution has been produced to the undersigned notary.
The contribution in the amount of eight hundred euro (EUR 800) is entirely allocated to the share capital.
<i>Third resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves to amend and fully restate the Company’s articles of association which
shall henceforth read as follows:
A. Name - Purpose - Duration - Registered office
Art. 1. Name. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name ECommerce
Holding II S.à r.l. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning com-
mercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.
Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign
companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio.
2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it
holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the
Company.
2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by
issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.
2.4 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities
which it considers useful for the accomplishment of these purposes, in view of its realisation by sale, exchange or other-
wise.
Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
Art. 4. Registered Office.
4.1 The registered office of the Company is established in Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by decision of the board of managers. It
may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by resolution of the shareholders,
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution
of the board of managers.
4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances
or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
traordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwiths-
tanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.
B. Share capital - Shares
Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company’s share capital is set at twenty-nine thousand nine hundred ninety-six Euros (EUR 29,996.00) with
a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each, represented by
5.1.1 twelve thousand five hundred (12,500) common shares (hereinafter “Common Shares”),
5.1.2 twelve thousand five hundred (12,500) series A shares (hereinafter “Series A Shares”),
5.1.3 one thousand six hundred eighty-eight (1,688) series B shares (hereinafter “Series B Shares”) and
5.1.4 three thousand three hundred eight (3,308) series C shares (hereinafter “Series C Shares”, the Series A Shares,
the Series B Shares and the Series C Shares hereinafter also referred to as “Preferred Shares”).
126110
L
U X E M B O U R G
The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by these
articles of association or by the Law.
5.2 The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
5.3 Each of (i) Global Fin Tech Holding S.à. r.l. (“Rocket”), (ii) HV Holtzbrinck Ventures Fund V GmbH & Co. KG
(“Holtzbrinck”), (iii) AI Lendico Holdings LLC ("Access"), (iv) TJT (B) (Bermuda) Investment Company Ltd. (“TJT”), (v)
David W. Zalaznick (“DZ”) and (vi) Aismare Lux Holdings S.à r.l. (“Aismare”; Rocket, Holtzbrinck, Access, TJT, DZ and
Aismare jointly the “Investors” and each an “Investor”) shall be entitled to subscribe for such amount of further shares
to be issued in the course of a capital increase implementing an investment offer of a third party (being neither a share-
holder nor a company affiliated to a shareholder within the meaning of sections 15 et seqq. German Stock Corporation
Act (AktG) (a “Third Party Investor”) and which has been approved with a majority vote of at least seventy-five per cent
(75%) of the votes of all shareholders of the Company (a “Third Party Investment”) - irrespective whether made by the
Third Party Investor or one or more matching shareholders - required to maintain up to its percentage ownership in the
Company prior to such capital increase under the same terms and conditions on which the Third Party Investment is
based on. The respective Investor shall inform the Company by binding declaration within three (3) weeks if it intends
to exercise its right pursuant to the foregoing sentence of this Article 5.3.
Art. 6. Shares.
6.1 The Company’s share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of
the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.
6.5 The Company may accept contributions without issuing shares or other securities in consideration and may allocate
such contributions to one or more distributable reserves. Decisions as to the use of any such distributable reserves are
to be taken by the shareholder(s) or the manager(s) as the case may be, subject to the Law and these articles of association.
Art. 7. Register of Shares - Transfer of Shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection
by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.
7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall
appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.
7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given
by the shareholders at a majority of three quarters of the share capital and subject to the provisions of any shareholders
agreement between the shareholders, if any, in particular, any rights of first refusal, rights of pre-emption or tag-along
rights or drag-along rights contained in any shareholders agreement between the shareholders. To the extent that such
approval has been granted, an additional consent to the transfer of shares is not required:
7.4.1 in any case of a transfer, assignment or any other disposal of shares by any Investor to a company affiliated to
such Investor within the meaning of sections 15 et seqq. German Stock Corporation Act (AktG);
7.4.2 in case of a sale, transfer, assignment or any other disposal of shares by any Investor to a company (x) which is
directly or indirectly Controlling, Controlled by or under common Control with (i) this Investor or (ii) by one or more
direct or indirect shareholders of the respective Investor (each a “Controlled Company”), whereas “Control” or “Con-
trolled” or “Controlling” shall mean the direct or indirect domination of the company by way of (a) managing the company
as managing shareholder, (b) holding the majority of shares or (c) holding the majority of voting rights by means of a
contractual voting pool, or (d) the unilateral ability to cause, directly or indirectly, the direction of the management and
policies of a person, whether through the ownership of voting securities or otherwise, or (y) in which the respective
Investor or one or more shareholders of such Investor has a direct or indirect majority shareholding;
7.4.3 in case of a transfer, assignment or any other disposal of shares (i) to a party acquiring shares under the simplified
employee participation or (ii) to the Company and/or any Investor pursuant to a call-option under a vesting scheme;
7.4.4 in case of any transfer, assignment or any other disposal of shares within the framework of transformation
procedures pursuant to the transformation law of Luxembourg, in particular (but without limitation) a merger of the
Company, if the shareholders of the Company hold more than fifty per cent (50%) in any surviving legal entity after such
transformation procedure.
7.5 In the cases provided for in art. 7.4.1 through 7.4.4 above, no duties to offer for sale apply, nor do any rights of
first refusal, rights of pre-emption or tagalong rights or drag-along rights in favour of other shareholders apply.
126111
L
U X E M B O U R G
7.6 Any transfer, assignment or any other disposal of shares shall become effective towards the Company and third
parties through the notification of the transfer, assignment or any other disposal to, or upon the acceptance of the transfer,
assignment or any other disposal by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.
7.7 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject
to the approval of such transfer given by shareholders holding at least three quarters of the share capital (a “Super
Majority”) (which, for these purposes, shall exclude the shares of the deceased shareholder). Such approval is, however,
not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse or any other legal
heir of the deceased shareholder.
Art. 8. Liquidation and Sale Preferences.
8.1 In case (i) of any sale of at least fifty per cent (50%) of all shares in the Company, or a swap or a take-over of the
Company in an economically comparable way in a single or more related transactions or in close time proximity to one
another, or (ii) of the liquidation of the Company or (iii) of any sale or transfer of shares in the Company either to third
parties or other shareholders that would result in either more than fifty per cent (50%) of the share capital or more than
fifty per cent (50%) of the voting rights being owned by the acquiring party/parties (change of control) as a result of one
or more related acquisitions, (each of the events described in (i), (ii) and (iii) is hereinafter referred to as a “Liquidity
Event”), the proceeds (“Exit Proceeds”) - subject to Article 8.2 through Article 8.4 below - will be distributed in accor-
dance with Article 8.5 to the shareholders pro rata corresponding to their participation in the Liquidity Event.
8.2 On a first level (“First Level”) the holders of Series C Shares shall receive an amount which equals the amount of
their respective total investment made in the Company (consisting of the nominal amount of the Series C Shares acquired
by that holder and any share premium and/or other capital contribution (account 115) paid by that holder to the Com-
pany). If the Exit Proceeds do not suffice for the payments to be made on the First Level, the Exit Proceeds shall be
allocated to the holders of Series C Shares pro rata to the amounts that would have been allocated to the holders of
Series C Shares on the First Level if the Exit Proceeds were sufficient.
8.3 On a second level (“Second Level”) the holders of Series B Shares shall receive an amount which equals the amount
of their respective total investment made in the Company (consisting of the nominal amount of the Series B Shares
acquired by that holder and any share premium and/or other capital contribution (account 115) paid by that holder to
the Company). If the Exit Proceeds do not suffice for the payments to be made on the Second Level, the Exit Proceeds
shall be allocated to the holders of Series B Shares pro rata to the amounts that would have been allocated to the holders
of Series B Shares on the Second Level if the Exit Proceeds were sufficient.
8.4 On a third level (“Third Level”) the holders of Series A Shares shall receive an amount which equals the amount
of their respective total investment made in the Company (consisting of the nominal amount of the Series A Shares
acquired by that holder and any share premium and/or other capital contribution (account 115) paid by that holder to
the Company). If the Exit Proceeds do not suffice for the payments to be made on the Preferred Level, the Exit Proceeds
shall be allocated to the holders of Series A Shares pro rata to the amounts that would have been allocated to the holders
of Series A Shares on the Preferred Level if the Exit Proceeds were sufficient.
8.5 After the payments on the First, the Second and the Third Level have been made, the remaining Exit Proceeds
shall be allocated on a common level (“Common Level”) to all shareholders pro rata corresponding to their participation
in the Liquidity Event. Any amounts received by any shareholder on the First, the Second and the Third Level shall reduce
the amount to be allocated to such shareholder on the Common Level and shall be allocated subsequently pursuant to
this Common Level provided that no shareholder shall be obliged to repay any amount received on the First, the Second
and the Third Level. The allocation at the Common Level shall be made until all Exit Proceeds have been distributed to
the shareholders. Irrespective of whether or not the sale of shares is made in one Liquidity Event or after the Liquidity
Event in one transaction or more transactions no shareholder shall receive for the sale of all of its shares (and shall repay
any exceeding amount to the other shareholders) an amount exceeding the higher of (i) its share in the total Exit Proceeds
or proceeds pro rata to the shares sold on a common equivalent basis or (ii) the amount allocated to such shareholder
on the First, the Second and the Third Level from a subsequent sale. All rights related to the liquidity preference stipulated
herein can only be exercised once.
8.6 The preferred allocation on the First, the Second and the Third Level applies to each of the respective Preferred
Shares as long as on the respective Preferred Shares the respective amount stipulated in Article 8.2 through Article 8.4
has not yet been distributed once.
Art. 9. Redemption of Shares.
9.1 The Company may redeem its own shares. The voting rights of any of its shares held by the Company are suspended,
for as long as they are held by the Company.
9.2 Shares of a shareholder may be redeemed without such shareholder’s consent, if:
9.2.1 insolvency proceedings are opened over the assets of the shareholder or the opening of insolvency proceedings
is rejected for lack of assets;
9.2.2 the share of a shareholder is seized or enforcement proceedings are otherwise initiated against such share and
such enforcement proceedings are not finally closed within two (2) months.
126112
L
U X E M B O U R G
Upon receipt by such shareholder of the declaration of redemption sent by the board of managers, the shares shall
automatically be redeemed without any further action being required. The present articles together with the declaration
of redemption constitute together a valid instrument in writing for the purposes of article 190 of the Law and the Company
hereby acknowledges and accepts the transfer of the shares in such case and undertakes to register the transfer in its
share register and to proceed with the relevant filings required by law.
9.3 If the share is held by several persons, it is sufficient that the ground for redemption exists with respect to one
person; independently of this, several jointly entitled persons can only exercise the shareholders’ rights in a uniform way
through one jointly entitled person to be appointed for this purpose without undue delay after the joint entitlement
arises.
9.4 The board of managers may declare a redemption. The redemption declaration takes effect upon receipt of the
declaration by the shareholder concerned and if a respective shareholders’ resolution is adopted (except in case of Article
9.2 of these articles of association, in which no declaration by the shareholder concerned and no respective shareholders’
resolution is required).
Art. 10. Compensation for Redemption.
10.1 Redemption is made against compensation.
10.2 The compensation consists of a total amount equal to the market value of the redeemed shares. The effective
date is the date before the redemption resolution.
10.3 The compensation for redemption shall be due and payable immediately upon redemption of the shares.
10.4 The withdrawing shareholder shall not be entitled to request the Company to provide security for outstanding
amounts including interest.
10.5 In the event of dispute regarding the amount of the payable compensation for redemption, such compensation is
to be determined by an auditor as expert arbitrator who shall jointly be appointed by the shareholders. If no agreement
is reached, the expert arbitrator shall be selected by the President of the Tribunal d’Arrondissement upon request of a
shareholder or of the Company. The decision of the expert arbitrator shall be binding. The costs of the expert opinion
shall be borne by the Company and the requesting shareholder in equal parts, the part allocated to such shareholder shall
be set off with the compensation for redemption and the compensation for redemption shall be reduced accordingly.
The shareholder shall bear the remaining costs in case the redemption price does not cover the costs allocated to the
shareholder for the expert opinion.
Art. 11. Request of Assignment in lieu of Redemption.
11.1 The Company may decide that, in lieu of redemption, the shareholder concerned shall transfer the shares to a
person named by the Company (including another shareholder of the Company), including also partial redemption or
partial assignment of the shares to the Company or to a person named by the Company.
11.2 This Article 11 applies with the proviso that the compensation, as provided for in Article 10 of these articles of
association, for the shares to be assigned is owed by the person acquiring the shares and that the Company shall be liable
like a guarantor.
C. Decisions of the shareholders
Art. 12. Collective Decisions of the Shareholders.
12.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these
articles of association.
12.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
12.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise
conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case,
each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his
vote in writing.
12.4 The shareholders’ resolutions are passed in meetings. Unless mandatory law prescribes another form, they can
also be passed outside meetings in writing (including e-mail or fax) or telephone voting if such procedure is requested by
a shareholder and no other shareholder declares its dissent with the procedure within two (2) weeks towards the board
of managers of the Company in written form. If no dissent is declared within the two (2) weeks pursuant to the foregoing
sentence the votes of the shareholders which are not participating in the voting shall be deemed to be abstention from
voting. Written resolutions must be signed by each shareholder and the written record must be sent to each shareholder
without undue delay. Resolutions not passed in writing must be confirmed in writing. Such confirmation only has decla-
ratory significance.
12.5 Unless a notarial record is made of shareholders’ resolutions, a written record must be made of every resolution
passed at shareholders’ meetings (for purposes of proof, not as a precondition of validity) without undue delay, which
must state the date and form of the resolution passed, the content of the resolution and the votes cast. The written
record must be sent to each shareholder in writing without undue delay.
126113
L
U X E M B O U R G
12.6 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of
shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by
the sole shareholder.
Art. 13. General Meetings of Shareholders.
13.1 Meetings of shareholders may be held at the registered office of the Company or at such place and time as may
be specified in the respective convening notices of meeting.
13.2 The shareholders’ meeting is called by registered letter (registered personal delivery, registered delivery or
registered letter with confirmation of receipt) to each shareholder, stating the place, date, time and agenda, with a period
of notice of at least four (4) weeks for ordinary shareholders’ meetings and at least two (2) weeks for extraordinary
shareholders’ meetings. The period of notice begins to run on the day following postage. The day of the shareholders’
meeting is not counted in the calculation of the period of notice.
13.3 If all shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived convening
requirements, the meeting may be held without prior notice.
13.4 Each shareholder is entitled to be accompanied or represented at the shareholders’ meeting by another share-
holder authorised by a written power of attorney or by a lawyer, tax advisor or auditor under a professional duty of
confidentiality.
13.5 Unless a notarial record is made of the negotiations of the shareholders’ meeting, a written record must be made
concerning the course of the meeting (for purposes of proof, not as a precondition of validity), which must state the place
and date of the meeting, the participants, the items on the agenda, the main content of the negotiations and the share-
holders’ resolutions. The written record must be signed by all shareholders present or represented in the shareholders’
meeting (for purposes of proof, not as a precondition of validity). Each shareholder must be sent a copy of the written
record.
Art. 14. Quorum and Vote.
14.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
14.2 A shareholders’ meeting only constitutes a quorum if at least fifty per cent (50%) of the share capital is represented.
Save for a higher majority provided in these articles of association or by Law, collective decisions of the Company’s
shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share
capital. If there is no quorum, a new shareholders’ meeting with the same agenda must be called without undue delay in
compliance with Article 13.2. This shareholders’ meeting then shall constitute a quorum regardless of the share capital
represented, if this was point ed out in the notice calling the meeting and the decisions shall be taken at the majority of
the votes cast.
Art. 15. Change of Nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous
consent.
Art. 16. Amendments of Articles of Association. Any amendment of these articles of association requires the approval
of (i) a majority in number of shareholders (ii) who are also a Super Majority.
Art. 17. Shareholders’ Resolutions Requiring Specific Majority.
17.1 Shareholders’ Resolutions regarding the following subjects must be taken by a Super Majority:
17.1.1 disposition of all Company’s assets or of a significant part of the Company’s assets including the resolution with
respect to the liquidation of the Company;
17.1.2 resolution with respect to the merger, separation and transformation of the Company;
17.1.3 conclusion of intra-group agreements (Unternehmensverträge within the meaning of sections 291 et seqq.
German Stock Corporation Act (AktG));
17.1.4 conclusion of company participations (for the avoidance of doubt, other than by way of disposal of shares) of
any kind including silent partnerships and all agreements by which the other contractual party is granted a participation
in the Company’s profit or any payment that is dependent on the amount of the Company’s profit; this does not include
agreements with shareholders or employees of the Company, including agreements concluded in light of a prospective
status as shareholder or employee, as well as agreements with third parties within the ordinary course of business, e.g.
agreements between the Company and advertising partners.
17.2 Resolutions regarding the following subjects must be taken by a Super Majority and also require the prior consent
of the Investors.
17.2.1 exclusion of subscription rights in case of capital increases;
17.2.2 acquisition of the Company’s own shares, with the exception of acquisitions in accordance with Article 9.2 and
transfers in accordance with Article 11.1 of these articles of association.
126114
L
U X E M B O U R G
17.3 Whenever the capital of the Company is divided into different classes of shares the specific rights and obligations
attached to any class may be varied or abrogated with the unanimous consent in writing of the shareholders who hold
all the issued shares of that class.
D. Board of managers - Advisory board
Art. 18. Powers of the Sole Manager - Composition and Powers of the Board of Managers.
18.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers
form a board of managers.
18.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not
expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of
association is to be construed as a reference to the “sole manager”.
18.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any
actions necessary or useful to fulfil the Company’s corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the
Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.
Art. 19. Election, Removal and Term of Office of Managers.
19.1 The manager(s) shall be elected by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration
and term of office.
19.2 The managers shall be elected and may be removed from office at any time, with or without cause.
19.3 The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two (2) different classes, being class A
managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant
shareholders resolutions and the managers be identified with respect to the class they belong.
Art. 20. Vacancy in the Office of a Manager.
20.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or
otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the replaced manager by the remaining managers until the next meeting of shareholders which shall resolve on the
permanent appointment, in compliance with the applicable legal provisions.
20.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company’s sole manager, such vacancy must be filled without undue
delay by the general meeting of shareholders.
Art. 21. Convening Meetings of the Board of Managers.
21.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held
at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.
21.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers at least twenty-four (24)
hours in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such document being
sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined
in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.
21.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive
any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of
managers.
Art. 22. Management.
22.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not
need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
22.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any
such meeting.
22.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either
in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.
22.4 Meetings of the board of managers may also be held by conferencecall or video conference or by any other means
of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis and
allowing an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a parti-
cipation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.
22.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or
represented at a meeting of the board of managers.
22.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,
if any, shall not have a casting vote. In the event however the general meeting of shareholders has appointed different
126115
L
U X E M B O U R G
classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only
be validly taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which
may be represented).
22.7 The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in
writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be
the date of the last signature.
22.8 The managers shall require the consent of at least two (2) of the shareholders Rocket, Holtzbrinck, Access, TJT,
DZ and Aismare which at the relevant time hold jointly more than fifty per cent (50%) of the Company’s registered share
capital (the “Investor Majority”) for the legal transactions and measures specified below. No consent is required if such
legal transactions and measures have been precisely defined and have in advance been approved by an adopted budget
with the consent of the Investor Majority:
22.8.1 formation, acquisition, closure or disposal of enterprises or partialbusinesses;
22.8.2 amendment of statutes, these articles of association, shareholder agreements and similar contracts as well as
exercise (or waiver) of shareholders’ rights in companies in which an interest is held;
22.8.3 acquisition, sale and encumbrance of real estate and similar rights or rights in real estate;
22.8.4 establishment, relocation and closure of branch establishments and places of business;
22.8.5 modification of the fields of business of the Company and the termination of existing and commencement of
new fields of business (Geschäftsfelder);
22.8.6 approval of the annual plan, in particular the budget plan for each following year;
22.8.7 assumption of sureties, guarantees or similar liabilities in excess of an amount of two hundred thousand Euros
(EUR 200,000.00) in aggregate;
22.8.8 granting of loans in excess of two hundred thousand Euros (EUR 200,000.00) in the individual case, excluding,
however, such loans between the Company and direct and indirect subsidiaries of the Company;
22.8.9 conclusion and termination of credit and loan agreements and other financial agreements in excess of two
hundred thousand Euros (EUR 200,000.00) in the individual case and amendments to the credit framework and extraor-
dinary repayments, excluding, however, such agreements between the Company and direct and indirect subsidiaries of
the Company;
22.8.10 futures transactions concerning currencies, securities and exchangetraded goods and rights as well as other
transactions with derivative financial instruments;
22.8.11 granting, introduction and amendment of pension commitments of any kind;
22.8.12 conclusion, amendment and dissolution of employment contracts providing for a remuneration in excess of
one hundred fifty thousand Euros (EUR 150,000) per year;
22.8.13 promise or granting of bonuses and gratuities of any kind outside of existing employment contracts as well as
payment of advances or grant of loans to managers and employees in excess of fifty thousand Euros (EUR 50,000) in the
individual case;
22.8.14 conclusion, amendment or termination of Company collective agreements, works agreements (of substantial
importance) and of general guidelines regarding the Company pension scheme;
22.8.15 institution and termination of legal disputes, in particular, arbitration proceedings involving a judicial amount
in controversy of more than ten thousand Euros (EUR 10,000.00) in the individual case;
22.8.16 acquisition, disposition and/or licensing of rights of use of any kind with respect to intellectual property rights
including copyrights or any other property rights as well as the passing on of know-how for the independent exploitation
by the enterprise and/or a third party, as well as the grant or acquisition of licences, as well as the amendment of
agreements with respect thereto, excluding, however, such dispositions between the Company and direct and indirect
subsidiaries of the Company;
22.8.17 granting of a power of attorney, by which a proxy grants power of attorney to another proxy, in order to
conclude an agreement with him at the expense of the Company;
22.8.18 transactions of the Company and its investment companies with affiliated legal entities and individuals. As such
shall be deemed to be direct or indirect shareholders of the Company (including, for the avoidance of doubt, European
Founders Fund GmbH (“EFF”) and EFF’s direct and indirect shareholders (i.e. the Samwer brothers), but excluding any
direct or indirect shareholders of Holtzbrinck and/or Access and/or TJT and/or DZ and/or Aismare), affiliated companies
pursuant to sections 15 et seqq. German Stock Corporation Act (AktG) as well as relatives pursuant to section 15 German
Tax Code (AO) of direct or indirect shareholders, as far as the latter (except EFF and EFF’s direct and indirect share-
holders) - individually or jointly - hold, directly or indirectly, a majority interest. The consent requirement pursuant to
this Article 22.8.18 does not apply if the transaction belongs to the ordinary course of business of the Company and is
at arm’s length;
22.8.19 changing of the Company’s auditors;
126116
L
U X E M B O U R G
22.8.20 granting, setting up or amending any employee incentive scheme (including the grant of any share options)
outside the existing simplified employee participation agreed upon between the shareholders in a shareholders’ agree-
ment;
22.8.21 exercise of voting rights and other rights in a company in which the Company is a shareholder to the extent
that this exercise would require the consent of the Investor Majority under these articles of association if the Company
was concerned, i.e. according to this Article 22.8 or Article 17.
22.9 If the consent is required as aforesaid for the acquisition, sale or encumbrance of objects, the consent is also
required for the contractual obligation relating thereto. The shareholders’ meeting may by resolution determine further
transactions and measures requiring the consent of the Investor Majority. The Investor Majority may give its consent also
in advance for certain groups and kinds of transactions and measures.
22.10 The shareholders may by shareholders’ resolution adopt rules of procedure for the managers.
22.11 The management shall ensure that, as far as legally possible, the regulations in this Article 22 apply in the same
manner to all related companies in which the Company holds a majority interest, directly or indirectly, at present or in
the future.
Art. 23. Minutes of the Meeting of the Board of Managers; Minutes of the Decisions of the Sole Manager.
23.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by
the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. In the event the general meeting of
shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) under the joint
signature of one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation). Copies or excerpts
of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if any, or
by any two (2) managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers
(namely class A managers and class B managers) under the joint signature of one (1) class A manager and one (1) class B
manager (including by way of representation).
23.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.
Art. 24. Dealing with Third Parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the
signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers;
in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A manager
and class B manager), the Company will only be validly bound by the joint signature of at least one (1) class A manager
and one (1) class B manager (including by way of representation) or (ii) by the joint signatures or the sole signature of
any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such
delegation.
Art. 25. Advisory Board.
25.1 The Company shall have an advisory board. It shall consist of seven (7) voting members. The shareholders’ meeting
may by way of a shareholders’ resolution increase or decrease the number of voting members of the advisory board.
25.2 The shareholders’ meeting shall only set and/or amend rules of procedure for the advisory board by way of a
unanimous shareholders’ resolution.
25.3 The voting members of the advisory board shall be nominated, withdrawn or replaced by each member’s res-
pective appointing shareholder by written notification towards the Company as follows:
25.3.1 Four (4) voting members of the advisory board shall be nominated by the shareholder Rocket in its sole dis-
cretion;
25.3.2 One (1) voting member of the advisory board shall be nominated by the shareholder Holtzbrinck in its sole
discretion;
25.3.3 One (1) voting member of the advisory board shall be nominated by the shareholder Access in its sole discretion;
and
25.3.4 One (1) voting member of the advisory board shall be nominated by the shareholder Aismare in its sole dis-
cretion.
25.4 The advisory board may have non-voting members of the advisory board as observers.
25.5 The advisory board shall have a chairman and a deputy chairman. A voting member nominated by Rocket shall
be the chairman of the advisory board. The rules of procedure of the advisory board may provide for further provisions
in particular on the self organization of the advisory board. The advisory board shall adopt resolutions with the simple
majority of votes cast. The advisory board shall hold meetings on a regular basis, at least once every calendar quarter.
25.6 The advisory board shall be competent for advising the Company’s managers on the strategy and operational
matters and shall discuss with the managers the budget of the Company.
25.7 The advisory board is not a supervisory board within the meaning of article 60bis-11 et seq. of the Law.
126117
L
U X E M B O U R G
E. Audit and supervision
Art. 26. Auditor(s).
26.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company
shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.
26.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting
of shareholders.
26.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
26.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d’entreprises agréé
(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies’ register and the
accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.
26.5 An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its
approval.
F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends
Art. 27. Financial Year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end
on the thirty-first of December of the same year.
Art. 28. Annual Accounts and Allocation of Profits.
28.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of
the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.
28.2 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve.
This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten
per cent (10%) of the share capital of the Company.
28.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the
contributing shareholder agrees with such allocation.
28.4 In case of a share capital reduction, the Company’s legal reserve may be reduced in proportion so that it does
not exceed ten per cent (10%) of the share capital.
28.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the
remainder of the Company’s annual net profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.
28.6 Subject to Article 8, distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they
hold in the Company.
Art. 29. Interim Dividends - Share Premium and Assimilated Premiums.
29.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared
by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed shall
be allocated where applicable in accordance with the provisions of Article 8 and may not exceed realized profits since
the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable reserves, but decreased by losses
carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles of association do not allow to be
distributed.
29.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the share-
holders subject to the provisions of the Law and these articles of association.
G. Liquidation
Art. 30. Liquidation. In the event of dissolution of the Company in accordance with Article 3.2 of these articles of
association, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting
of shareholders deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.
Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realization of the assets and
payment of the liabilities of the Company.
H. Final clause - Governing law
Art. 31. Governing Law.
31.1 All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the Law and any
shareholders’ agreement which may be entered into from time to time between the shareholders and the Company, and
which may supplement certain provisions of these articles. Where any matter contained in these articles conflicts with
the provisions of any shareholders’ agreement, such shareholders’ agreement shall prevail inter partes and to the extent
permitted by Luxembourg law.
31.2 These articles are worded in English followed by a German translation; in case of divergence between the English
and the German text, the English version shall prevail.
126118
L
U X E M B O U R G
There being no further business, the meeting is closed.
<i>Costs and expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are
estimated at approximately one thousand four hundred Euros (EUR 1,400.-).
<i>Statementi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,
the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing party and
in case of divergence between the English and the German text, the English version will prevail.
WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this
document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name
and residence, the said proxyholder signed together with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:
Im Jahre zweitausendvierzehn, am vierten Juli.
Vor uns, dem unterzeichnenden Notar Maître Carlo WERSANDT, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Lu-
xemburg.
SIND ERSCHIENEN:
1. Global Fin Tech Holding S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) ge-
gründet und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und
Gesellschaftsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) unter der Nummer B 184.665, mit Sitz in 7, avenue J.P.
Pescatore, L-2324 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg („Global Fin Tech Holding“),
Inhaber von zwölftausendvierhundertneunundneunzig (12.499) Stammanteilen und fünftausendzweihundertfünfzig
(5.250) Anteilen der Serie A,
hier vertreten durch Herrn Luis AGUERRE ENRÍQUEZ, Doctor en Derecho, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß
einer Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, am 30. Juni 2014;
2. Bambino 53. V V UG (haftungsbeschränkt), eine Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) bestehend unter
deutschem Recht, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland, unter der Nummer
HRB 126893 B, mit Sitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Deutschland („Bambino 53. V V“),
Inhaber eines (1) Stammanteils,
hier vertreten durch Herrn Luis AGUERRE ENRÍQUEZ, Doctor en Derecho, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß
einer Vollmacht vom 30. Juni 2014, ausgestellt in Berlin, Deutschland;
3. HV Holtzbrinck Ventures Fund V GmbH & Co. KG, eine Kommanditgesellschaft nach deutschem Recht mit sat-
zungsmäßigem Sitz in München, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München, Deutschland,
unter der Nummer HRA 98863, mit Geschäftssitz in Kaiserstraße 14b, 80801 München, Deutschland, vertreten durch
ihren unbeschränkt haftenden Gesellschafter (general partner), HV Holtzbrinck Ventures Holding GmbH, eine Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung bestehend unter deutschem Recht, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts
München, Deutschland, unter der Nummer HRB 185098 B, mit Sitz in Kaiserstraße 14b, 80801 München, Deutschland
(„Holtzbrinck“),
Inhaber von dreitausendsechshundertfünfundzwanzig (3.625) Anteilen der Serie A, achthundertvierundvierzig (844)
Anteilen der Serie B und achthundertvierundfünfzig (854) Anteilen der Serie C,
hier vertreten durch Herrn Luis AGUERRE ENRÍQUEZ, Doctor en Derecho, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß
einer Vollmacht vom 4. Juli 2014, ausgestellt in München, Deutschland;
4. Al Lendico Holdings LLC, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (limited liability company) nach dem Recht
des Bundesstaates Delaware, Vereinigte Staaten von Amerika, eingetragen beim Secretary of State des Bundesstaates
Delaware unter der Eintragungsnummer 5482207, mit satzungsmäßigem Sitz in 2711 Centerville Road, Suite 400, Wil-
mington, Delaware 19808, Vereinigte Staaten von Amerika („Access“),
Inhaber von dreitausendsechshundertfünfundzwanzig (3.625) Anteilen der Serie A, achthundertvierundvierzig (844)
Anteilen der Serie B und achthundertvierundfünfzig (854) Anteilen der Serie C,
hier vertreten durch Herrn Luis AGUERRE ENRÍQUEZ, Doctor en Derecho, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß
einer Vollmacht vom 30. Juni 2014, ausgestellt in New York, Vereinigte Staaten von Amerika;
5. TJT (B) (Bermuda) Investment Company Ltd., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (limited liability company)
nach dem Recht der Bermuda-Inseln, mit satzungsmäßigem Sitz in Hamilton, Bermuda, mit Geschäftssitz in Clarendon
House, 2 Church Street, Hamilton, Bermuda HM11 („TJT“),
Inhaber von vierhundert (400) Anteilen der Serie C,
126119
L
U X E M B O U R G
hier vertreten durch Herrn Luis AGUERRE ENRÍQUEZ, Doctor en Derecho, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß
einer Vollmacht vom 30. Juni 2014, ausgestellt in Bermuda;
6. Herr David W. Zalaznick, geboren am 16. April 1954 in New York, Vereinigte Staaten von Amerika, geschäftsansässig
in 9 West 57
th
Street - 33
rd
Floor, New York, NY 10019, USA („DZ“),
Inhaber von vierhundert (400) Anteilen der Serie C,
hier vertreten durch Herrn Luis AGUERRE ENRÍQUEZ, Doctor en Derecho, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß
einer Vollmacht vom 30. Juni 2014, ausgestellt in New York, Vereinigte Staaten von Amerika; und
7. Aismare Lux Holdings S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) gegründet
und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesell-
schaftsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) unter der Nummer B 176.544, mit Sitz in 6C, rue Gabriel
Lippmann, L-5365 Munsbach, Großherzogtum Luxemburg („Aismare“),
zukünftiger Inhaber von achthundert (800) Anteilen der Serie C und teilnahmeberechtigt für Punkt 3 der Tagesordnung,
hier vertreten durch Herrn Luis AGUERRE ENRÍQUEZ, Doctor en Derecho, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß
einer Vollmacht vom 1. Juli 2014, ausgestellt in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
Besagte Vollmachten, welche von dem Bevollmächtigten der erschienenen Parteien und dem Notar ne varietur para-
phiert wurden, werden der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.
Die unter Punkt 1 bis 6 aufgelisteten Parteien (die „Bestehenden Gesellschafter“) sind alle Gesellschafter und vertreten
das gesamte Gesellschaftskapital der ECommerce Holding II S.à r.l. (die „Gesellschaft”), einer Gesellschaft mit beschränk-
ter Haftung (société à responsabilité limitée), gegründet und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxem-
burg, mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels-
und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 177.435, gegründet am 7. Mai 2013 gemäß einer Urkunde des
unterzeichnenden Notars, welche am 10. Juli 2013 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1651
veröffentlicht wurde. Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt am 20. Juni 2014 gemäß einer Urkunde des unter-
zeichnenden Notars geändert, welche noch nicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht
wurde. Die Satzung der Gesellschaft wurde seitdem nicht geändert.
Da die Bestehenden Gesellschafter das gesamte Gesellschaftskapital vertreten und erklären, auf jegliche Ladungsfor-
malitäten verzichtet zu haben, ist die Gesellschafterversammlung ordnungsgemäß zusammengekommen und kann wirksam
über alle Punkte der folgenden Tagesordnung verhandeln, wobei Aismare ausschließlich für Punkt 3 der folgenden Ta-
gesordnung teilnahme- und stimmberechtigt ist:
<i>Tagesordnungi>
1. Aufnahme von Aismare Lux Holdings S.à r.l., einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité
limitée) gegründet und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Han-
delsund Gesellschaftsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) unter der Nummer B 176.544, mit Sitz in 6C, rue
Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Großherzogtum Luxemburg, als neuer Gesellschafter der Gesellschaft.
2. Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von neunundzwanzigtausendein-
hundertsechsundneunzig Euro (EUR 29.196) um einen Betrag von achthundert Euro (EUR 800) auf einen Betrag von
neunundzwanzigtausendneunhundertsechsundneunzig Euro (EUR 29.996) durch die Ausgabe von achthundert (800) An-
teilen der Serie C mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1).
3. Änderung und vollständige Neufassung der Satzung der Gesellschaft.
Nach ordnungsgemäßer Prüfung jedes Tagesordnungspunkts fasst die Gesellschafterversammlung einstimmig die fol-
genden Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung nimmt Aismare Lux Holdings S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (so-
ciété à responsabilité limitée) gegründet und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, eingetragen
im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) unter der Nummer B
176.544, mit Sitz in 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Großherzogtum Luxemburg, als neuen Gesellschafter
der Gesellschaft an.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt, das Gesellschaftskapital der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von
neunundzwanzigtausendeinhundertsechsundneunzig Euro (EUR 29.196) um einen Betrag von achthundert Euro (EUR 800)
auf einen Betrag von neunundzwanzigtausendneunhundertsechsundneunzig Euro (EUR 29.996) durch die Ausgabe von
achthundert (800) Anteilen der Serie C mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1), zu erhöhen.
<i>Zeichnungi>
Die achthundert (800) neuen Anteile der Serie C wurden ordnungsgemäß von Aismare, vorbenannt, zu einem Preis
von achthundert Euro (EUR 800) gezeichnet.
126120
L
U X E M B O U R G
<i>Zahlungi>
Die von Aismare, vorbenannt, gezeichneten achthundert (800) Anteile der Serie C wurden vollständig eingezahlt durch
eine Bareinlage in Höhe von achthundert Euro (EUR 800).
Der Nachweis über die Existenz und den Wert der oben bezeichneten Einlage wurde dem unterzeichnenden Notar
erbracht.
Die Einlage in Höhe von achthundert Euro (EUR 800) wird vollständig dem Gesellschaftskapital zugeführt.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt die Änderung und vollständige Neufassung der Satzung der Gesellschaft,
welche nunmehr wie folgt lautet:
„A. Name - Zweck - Dauer - Sitz
Art. 1. Name. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen
ECommerce Holding II S.à r.l. (die „Gesellschaft”), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über
Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Ge-
sellschaften, sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung
oder auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung,
Kontrolle und Entwicklung ihrer Beteiligungen.
2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder
Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören Garantien geben,
Sicherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.
2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere
durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und
Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheinen bzw. Wertpapieren.
2.4 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur, sowie
solche, welche geistiges Eigentum oder Grundeigentum betreffen, vornehmen, die ihr zur Erreichung dieser Zwecke
förderlich erscheinen, im Hinblick auf deren Verwertung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Art.
Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden,
welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird.
Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Rates der Geschäftsführer
verlegt werden. Durch einen Gesellschafterbeschluss, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und
Weise gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.
4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer im
Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.
4.4 Sollte der Rat der Geschäftsführer entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale
Entwicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an
ihrem Gesellschaftssitz beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz bis zur endgültigen Beendigung dieser
außergewöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben
keine Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes
eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.
B. Gesellschaftskapital - Anteile
Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt neunundzwanzigtausendneunhundertsechsundneunzig Euro (EUR
29.996) mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1), bestehend aus
5.1.1 zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteilen (die „Stammanteile”),
5.1.2 zwölftausendfünfhundert (12.500) Anteilen der Serie A (die „Anteile der Serie A“),
5.1.3 eintausendsechshundertachtundachtzig (1.688) Anteilen der Serie B (die „Anteile der Serie B“), und
5.1.4 dreitausenddreihundertacht (3.308) Anteilen der Serie C (die „Anteile der Serie C”, wobei die Anteile der Serie
A, die Anteile der Serie B und die Anteile der Serie C im Folgenden auch als „Vorzugsanteile“ bezeichnet werden).
126121
L
U X E M B O U R G
Die mit den Anteilen verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es wird in dieser Satzung oder
durch das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.
5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-
zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.
5.3 (i) Global Fin Tech Holding S.à r.l. („Rocket“), (ii) HV Holtzbrinck Ventures Fund V GmbH & Co. KG („Holtz-
brinck“), (iii) Al Lendico Holdings LLC („Access“), (iv) TJT (B) (Bermuda) Investment Company Ltd. (“TJT”), (v) David
W. Zalaznick („DZ“) und (vi) Aismare Lux Holdings S.à r.l. („Aismare“; Rocket, Holtzbrinck, Access, TJT, DZ und Aismare
gemeinschaftlich die „Investoren“ und jeweils ein „Investor“) ist zur Zeichnung einer Anzahl weiterer bei einer Kapital-
erhöhung ausgegebener Anteile berechtigt, wodurch ein Investmentangebot eines Dritten umgesetzt wird (bei dem es
sich weder um einen Gesellschafter, noch um eine mit einem Gesellschafter verbundene Gesellschaft im Sinne der §§ 15
ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG) (ein „Drittinvestor“) handelt), der mit einer Mehrheit von mindestens fünfund-
siebzig Prozent (75%) der Stimmen aller Gesellschafter der Gesellschaft zugestimmt wurde (eine „Investition eines
Dritten“) - unabhängig davon, ob diese vom Drittinvestor oder von einem oder mehreren vergleichbaren Gesellschaftern
erfolgte - und die zur Erhaltung der Beteiligungsquote an der Gesellschaft vor einer solchen Kapitalerhöhung erforderlich
ist, und dies zu denselben Bedingungen, wie bei einer Investition eines Dritten. Der jeweilige Investor hat die Gesellschaft
durch eine verbindliche Erklärung innerhalb von drei (3) Wochen darüber zu unterrichten, ob er sein Recht gemäß des
vorstehenden Satzes dieses Artikels 5.3 ausüben möchte.
Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit jeweils dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht über-
schreiten darf.
6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs oder die Insol-
venz oder ein vergleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.
6.5 Die Gesellschaft kann Einlagen ohne Ausgabe von Anteilen oder anderen Sicherheiten als Gegenleistung annehmen
und diese einer oder mehreren ausschüttbaren Rücklagen zuführen. Entscheidungen bezüglich der Verwendung solcher
ausschüttbarer Rücklagen werden gegebenenfalls von dem(den) Gesellschafter(n) oder Geschäftsführer(n) unter Berück-
sichtigung des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung getroffen.
Art. 7. Anteilsregister - Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden
kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.
7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten
wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft
ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.
7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.
7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern, die
drei Viertel des Gesellschaftskapitals halten und vorbehaltlich der Bestimmungen von Gesellschaftervereinbarungen zwi-
schen den Gesellschaftern, sofern vorhanden, insbesondere vorbehaltlich Vorkaufsrechten, Bezugsrechten oder Mitver-
kaufsrechten- oder Pflichten aus Gesellschaftervereinbarungen zwischen den Gesellschaftern übertragen werden. Sofern
eine solche Zustimmung erteilt wurde, ist eine weitere Einwilligung zur Übertragung von Anteilen nicht erforderlich:
7.4.1 bei einer Übertragung, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen durch einen Investor an
eine mit dem betreffenden Investor verbundene Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG);
7.4.2 bei einem Verkauf, einer Übertragung, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen durch
einen Investor an eine Gesellschaft, (x) welche direkt oder indirekt (i) diesen Investor oder (ii) einen oder mehrere direkte
oder indirekte Gesellschafter des betreffenden Investors (jeweils eine „Kontrollierte Gesellschaft“) Kontrolliert, von
diesem Kontrolliert Wird, oder unter der gemeinsamen Kontrolle von diesem steht, wobei die Worte „Kontrolle“ oder
„Kontrolliert Wird“ oder „Kontrolliert“ die direkte oder indirekte Beherrschung der Gesellschaft bezeichnet, durch (a)
die Leitung der Gesellschaft durch einen geschäftsführenden Gesellschafter, (b) das Halten der Mehrheit der Anteile oder
(c) das Halten der Mehrheit der Stimmrechte durch eine vertragliche Stimmvereinbarung, oder (d) die einseitige Fähigkeit,
direkt oder indirekt die Leitung der Geschäftsführung und Handlungsweisen einer Person, entweder durch das Halten
stimmberechtigter Wertpapiere oder anderweitig, zu beeinflussen, oder (y) in welcher der betreffende Investor oder
einer oder mehrere Gesellschafter dieses Investors eine direkte oder indirekte Mehrheitsbeteiligung haben;
7.4.3 bei einer Übertragung, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen (i) an einen Dritten,
welcher Anteile unter der vereinfachten Mitarbeiterbeteiligung erwirbt, oder (ii) an die Gesellschaft und/oder einen
beliebigen Investor gemäß einer Call-Option im Zusammenhang mit einer Vesting-Regelung;
126122
L
U X E M B O U R G
7.4.4 bei einer Übertragung, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen im Rahmen von Um-
wandlungsvorgängen gemäß des Umwandlungsrechts Luxemburgs, insbesondere (jedoch nicht beschränkt auf) eine
Verschmelzung der Gesellschaft, sofern die Gesellschafter der Gesellschaft nach einem solchen Umwandlungsvorgang
mehr als fünfzig Prozent (50%) an einer überlebenden juristischen Person halten.
7.5 In den in Artikel 7.4.1 bis 7.4.4 vorgesehenen Fällen gelten weder Verpflichtungen zu Verkaufsangeboten, noch
Vorkaufsrechte, Bezugsrechte oder Mitverkaufsrechte- oder Pflichten zugunsten anderer Gesellschafter.
7.6 Eine Übertragung, eine Abtretung oder eine andere Veräußerung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft
und Dritten gemäß Artikel 1690 des Code Civil wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung, Abtretung oder
anderen Veräußerung in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung, Abtretung oder anderen Veräußerung zugestimmt
hat.
7.7 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters nur an neue Gesellschafter übertragen werden,
wenn Gesellschafter, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals (eine „Qualifizierte Mehrheit“) halten, einer
solchen Übertragung zustimmen (wobei die Anteile des verstorbenen Gesellschafters für diese Zwecke nicht berück-
sichtigt werden). Eine derartige Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn die Anteile an Eltern, Nachkommen oder den/
die überlebende/n Ehepartner/in oder jeden anderen gesetzlichen Erben des verstorbenen Gesellschafters übertragen
werden.
Art. 8. Liquidations- und Verkaufspräferenzen.
8.1 Im Falle (i) eines Verkaufs von mindestens fünfzig Prozent (50%) aller Anteile an der Gesellschaft oder eines
Tausches oder einer Übernahme der Gesellschaft in wirtschaftlich vergleichbarer Weise in einer oder mehreren ver-
bundenen Transaktionen oder in zeitlicher Nähe zueinander, oder (ii) der Liquidation der Gesellschaft oder (iii) eines
Verkaufs oder einer Übertragung von Anteilen an der Gesellschaft entweder an Dritte oder an andere Gesellschafter,
was dazu führen würde, dass entweder mehr als fünfzig Prozent (50%) des Gesellschaftskapitals oder mehr als fünfzig
Prozent (50%) der Stimmrechte im Besitz der erwerbenden Partei bzw. Parteien wären (change of control), als Ergebnis
eines oder mehrerer verbundener Akquisitionen, (wobei jeder der unter (i), (ii) und (iii) beschriebenen Fälle im Folgenden
als „Liquiditätsereignis“ bezeichnet wird), werden die Erlöse („Exiterlöse“) -vorbehaltlich der Artikel 8.2 bis 8.4 - im
Einklang mit Artikel 8.5 auf einer pro rata-Basis entsprechend ihrer Beteiligung am Liquiditätsereignis an die Gesellschafter
verteilt.
8.2 Auf einer ersten Ebene („Erste Ebene”) erhalten die Inhaber von Anteilen der Serie C einen Betrag, welcher dem
Betrag ihrer jeweiligen Gesamtinvestition in die Gesellschaft entspricht (bestehend aus dem Nominalbetrag der von
diesem Inhaber erworbenen Anteile der Serie C und dem Agio und/oder anderen Kapitaleinlage (Konto 115 des Stan-
dardisierten Luxemburgischen Kontenplans), die von diesem Inhaber an die Gesellschaft gezahlt wurden). Sind nicht
ausreichend Exiterlöse für die Zahlungen auf der Ersten Ebene vorhanden, so werden die Exiterlöse an die Inhaber der
Anteile der Serie C auf einer pro-rata Basis zu den Beträgen verteilt, die an die Inhaber der Anteile der Serie C auf der
Ersten Ebene verteilt worden wären, wenn ausreichend Exiterlöse vorhanden gewesen wären.
8.3 Auf einer zweiten Ebene („Zweite Ebene”) erhalten die Inhaber von Anteilen der Serie B einen Betrag, welcher
dem Betrag ihrer jeweiligen Gesamtinvestition in die Gesellschaft entspricht (bestehend aus dem Nominalbetrag der von
diesem Inhaber erworbenen Anteile der Serie B und dem Agio und/oder anderen Kapitaleinlage (Konto 115 des Stan-
dardisierten Luxemburgischen Kontenplans), die von diesem Inhaber an die Gesellschaft gezahlt wurden). Sind nicht
ausreichend Exiterlöse für die Zahlungen auf der Zweiten Ebene vorhanden, so werden die Exiterlöse an die Inhaber der
Anteile der Serie B auf einer pro-rata Basis zu den Beträgen verteilt, die an die Inhaber der Anteile der Serie B auf der
Zweiten Ebene verteilt worden wären, wenn ausreichend Exiterlöse vorhanden gewesen wären.
8.4 Auf einer dritten Ebene („Dritte Ebene”) erhalten die Inhaber von Anteilen der Serie A einen Betrag, welcher dem
Betrag ihrer jeweiligen Gesamtinvestition in die Gesellschaft entspricht (bestehend aus dem Nominalbetrag der von
diesem Inhaber erworbenen Anteile der Serie A und dem Agio und/oder anderen Kapitaleinlage (Konto 115 des Stan-
dardisierten Luxemburgischen Kontenplans), die von diesem Inhaber an die Gesellschaft gezahlt wurden). Sind nicht
ausreichend Exiterlöse für die Zahlungen auf der Vorzugsebene vorhanden, so werden die Exiterlöse an die Inhaber der
Anteile der Serie A auf einer pro-rata Basis zu den Beträgen verteilt, die an die Inhaber der Anteile der Serie A auf der
Vorzugsebene verteilt worden wären, wenn ausreichend Exiterlöse vorhanden gewesen wären.
8.5 Nachdem die Zahlungen auf der Ersten, Zweiten und Dritten Ebene geleistet wurden, werden die übrigen Exiterlöse
auf einer gemeinsamen Ebene („Gemeinsame Ebene“) an alle Gesellschafter auf einer pro rata-Basis entsprechend ihrer
Beteiligung am Liquiditätsereignis verteilt. Sämtliche von einem Gesellschafter auf der Ersten, Zweiten und Dritten Ebene
erhaltenen Beträge mindern den von diesem Gesellschafter zu erhaltenden Betrag auf der Gemeinsamen Ebene und
werden anschließend entsprechend dieser Gemeinsamen Ebene zugeteilt, mit der Maßgabe, dass kein Gesellschafter zur
Rückzahlung eines auf der Ersten, Zweiten und Dritten Ebene erhaltenen Betrags verpflichtet ist. Die Zuteilung auf der
Gemeinsamen Ebene erfolgt solange, bis alle Exiterlöse an die Gesellschafter verteilt wurden. Unabhängig davon, ob der
Verkauf von Anteilen während eines Liquiditätsereignisses oder danach in einer oder mehreren Transaktionen erfolgt
oder nicht, hat kein Gesellschafter für den Verkauf all seiner Anteile einen Betrag zu erhalten (und übersteigende Beträge
an die anderen Gesellschafter zurückzuzahlen), der höher ist, (i) als sein Anteil an der Gesamtheit der Exiterlöse oder
Erlöse auf einer pro rata-Basis zu den Anteilen, die auf einer gemeinsamen und gleichwertigen Basis verkauft wurden oder
(ii) als der Betrag, der diesem Gesellschafter auf der Ersten, Zweiten und Dritten Ebene aus einem späteren Verkauf
126123
L
U X E M B O U R G
zugeteilt wurde. Sämtliche mit der hierin festgelegten Liquiditätspräferenz verbundenen Rechte können nur einmal aus-
geübt werden.
8.6 Die bevorzugte Zuteilung auf der Ersten, Zweiten und Dritten Ebene gilt für alle entsprechenden Vorzugsanteile
solange, wie bei den jeweiligen Vorzugsanteilen der jeweils in Artikel 8.2 bis Artikel 8.4 festgelegte Betrag noch nicht
verteilt wurde.
Art. 9. Rückkauf von Anteilen.
9.1 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen. Die Stimmrechte der von der Gesellschaft gehaltenen
Anteile werden so lange ausgesetzt, wie die Anteile von der Gesellschaft gehalten werden.
9.2 Anteile eines Gesellschafters können ohne Zustimmung eines solchen zurückgekauft werden, wenn:
9.2.1 ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des Gesellschafters eröffnet wird oder die Eröffnung eines Insolvenz-
verfahrens mangels Masse abgelehnt wird;
9.2.2 der Anteil des Gesellschafters gepfändet wurde oder Vollstreckungsverfahren anderweitig gegen diesen Anteil
eingeleitet wurden und diese Verfahren nicht innerhalb von zwei (2) Monaten vollständig eingestellt sind.
Mit Erhalt durch den Gesellschafter der vom Rat der Geschäftsführer gesendeten Rückkaufserklärung sind die Anteile
automatisch zurückgekauft, ohne dass es einer weiteren Handlung bedarf. Die vorliegende Satzung stellt gemeinsam mit
der Rückkaufserklärung ein gültiges Dokument im Sinne des Artikels 190 des Gesetzes von 1915 dar und die Gesellschaft
bestätigt hiermit die Kenntnisnahme der Übertragung der Anteile, akzeptiert diese und verpflichtet sich zur Eintragung
dieser Übertragung in ihrem Anteilsregister und zur entsprechenden gesetzlich geforderten Hinterlegung für diesen Fall.
9.3 Wird der Anteil von mehreren Personen gehalten, ist das Vorliegen eines Grundes zum Rückkauf in Bezug auf eine
Person ausreichend; unabhängig davon können mehrere gemeinschaftlich berechtigte Personen die Gesellschafterrechte
nur dann und einheitlich ausüben, wenn eine der gemeinschaftlich berechtigten Personen unverzüglich nach Eintritt der
gemeinschaftlichen Berechtigung zu diesem Zwecke ernannt wird.
9.4 Ein Rückkauf kann durch den Rat der Geschäftsführer erklärt werden. Die Rückkaufserklärung wird wirksam, sobald
der betreffende Gesellschafter die Erklärung erhält und ein entsprechender Gesellschafterbeschluss gefasst wird (außer
im Falle von Artikel 9.2 dieser Satzung, in welchem keine Erklärung des Gesellschafters und kein entsprechender Gesell-
schafterbeschluss erforderlich sind).
Art. 10. Ausgleichszahlung für den Rückkauf.
10.1 Der Rückkauf erfolgt gegen eine Ausgleichszahlung.
10.2 Die Ausgleichszahlung besteht aus einem Gesamtbetrag, welcher dem Marktwert der zurückgekauften Anteile
entspricht. Als Stichtag gilt der Tag vor dem Rückkaufsbeschluss.
10.3 Die Ausgleichszahlung für den Rückkauf ist unmittelbar mit dem Rückkauf der Anteile fällig und zahlbar.
10.4 Der ausscheidende Gesellschafter ist nicht dazu befugt, von der Gesellschaft Sicherheiten für ausstehende Beträge
zuzüglich Zinsen zu verlangen.
10.5 Bei Streitigkeiten hinsichtlich des Betrags der zu zahlenden Ausgleichszahlung für den Rückkauf ist diese Aus-
gleichszahlung von einem Wirtschaftsprüfer in der Eigenschaft als Schiedsgutachter, der von den Gesellschaftern gemein-
schaftlich ernannt wird, festzulegen. Wird über die Ernennung des Schiedsgutachters keine Einigung erzielt, so wird dieser
auf Ersuchen eines Gesellschafters oder der Gesellschaft vom Vorsitzenden des Bezirksgerichts (Tribunal d’Arrondisse-
ment) bestimmt. Die Entscheidung des Schiedsgutachters ist bindend. Die Kosten für das Gutachten werden von der
Gesellschaft und dem betreffenden Gesellschafter zu gleichen Teilen getragen, wobei der vom Gesellschafter zu tragende
Teil mit der Ausgleichszahlung für den Rückkauf verrechnet und die Ausgleichszahlung für den Rückkauf dementsprechend
herabgesetzt wird. Der Gesellschafter hat die übrigen Kosten zu tragen, sofern der Rückkaufspreis die dem Gesellschafter
zugewiesenen Kosten für das Gutachten nicht deckt.
Art. 11. Abtretung anstelle von Rückkauf.
11.1 Die Gesellschaft kann entscheiden, dass der betreffende Gesellschafter anstelle des Rückkaufs die Anteile an eine
von der Gesellschaft benannte Person (einschließlich eines anderen Gesellschafters) zu übertragen hat, auch im Falle eines
Teilrückkaufs oder einer Teilabtretung der Anteile an die Gesellschaft oder an eine von der Gesellschaft benannte Person.
11.2 Der vorliegende Artikel 11 gilt mit der Maßgabe, dass, wie in Artikel 10 dieser Satzung vorgesehen, die Aus-
gleichszahlung für die abzutretenden Anteile durch die die Anteile erwerbende Person geschuldet ist und dass die
Gesellschaft als Garant haftet.
C. Entscheidungen der Gesellschafter
Art. 12. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
12.1 Die Gesellschafterversammlung ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch das Gesetz und diese Satzung
ausdrücklich vorbehalten sind.
12.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.
12.3 Falls und solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, dürfen gemeinsame
Entscheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung vorbehalten wären, schriftlich gefasst werden. In die-
126124
L
U X E M B O U R G
sem Fall erhält jeder Gesellschafter den Text der zu fassenden Beschlüsse oder Entscheidungen in ausformulierter Form
und übt sein Stimmrecht schriftlich aus.
12.4 Gesellschafterbeschlüsse werden in Versammlungen gefasst. Sofern nicht zwingende gesetzliche Vorschriften eine
andere Form vorschreiben, können sie auch außerhalb von Versammlungen in schriftlicher Form (einschließlich E-Mail
oder Fax) oder durch telefonische Abstimmung gefasst werden, sofern ein solches Verfahren von einem Gesellschafter
ersucht wird und kein anderer Gesellschafter innerhalb von zwei (2) Wochen in schriftlicher Form Widerspruch gegen
dieses Verfahren gegenüber dem Rat der Geschäftsführer der Gesellschaft einlegt. Wird innerhalb von zwei (2) Wochen
kein Widerspruch gemäß des vorstehenden Satzes eingelegt, so werden die Stimmen der nicht an der Abstimmung teil-
nehmenden Gesellschafter als Enthaltungen gewertet. Schriftliche Beschlüsse sind von jedem Gesellschafter zu unter-
zeichnen und die Niederschrift ist jedem Gesellschafter unverzüglich zuzusenden. Beschlüsse, welche nicht in schriftlicher
Form gefasst werden, sind schriftlich zu bestätigen. Eine solche Bestätigung hat ausschließlich feststellende Bedeutung.
12.5 Von jedem Beschluss, der in Gesellschafterversammlungen gefasst wurde, ist unverzüglich eine Niederschrift
anzufertigen (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die Wirksamkeit), die das Datum und die Form des gefassten
Beschlusses, den Inhalt des Beschlusses und die abgegebenen Stimmen zu enthalten hat, es sei denn, die Gesellschafter-
beschlüsse wurden notariell beurkundet. Die Niederschrift muss jedem Gesellschafter unverzüglich in schriftlicher Form
zugesendet werden.
12.6 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschriften
des Abschnitts XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jede Bezugnahme auf die „Gesell-
schafterversammlung“ in der vorliegenden Satzung als Bezugnahme auf den Alleingesellschafter, je nach Zusammenhang
und soweit anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingesellschafter
ausgeübt.
Art. 13. Gesellschafterversammlung.
13.1 Gesellschafterversammlungen finden am Sitz der Gesellschaft oder an einem Ort und zu einer Zeit statt, welche
in der entsprechenden Einladung genauer bestimmt werden.
13.2 Die Gesellschafterversammlung wird mittels Einschreiben (Zustellung zu eigenen Händen, Einschreiben oder
Einschreiben mit Rückschein) an jeden Gesellschafter einberufen und beinhaltet den Ort, das Datum, die Uhrzeit und die
Tagesordnung, wobei bei ordentlichen Gesellschafterversammlungen eine Ankündigungsfrist von mindestens vier (4)
Wochen und bei außerordentlichen Gesellschafterversammlungen eine Ankündigungsfrist von mindestens zwei (2) Wo-
chen einzuhalten ist. Die Ankündigungsfrist beginnt am Tag nach dem Versand. Der Tag der Gesellschafterversammlung
wird bei der Berechnung der Ankündigungsfrist nicht berücksichtigt.
13.3 Falls alle Gesellschafter in einer Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten sind und auf Einladungs-
formalitäten verzichtet haben, kann die Versammlung auch ohne vorherige Ankündigung abgehalten werden.
13.4 Jeder Gesellschafter ist dazu berechtigt, bei der Gesellschafterversammlung von einem anderen durch eine
schriftliche Vollmacht dazu berechtigten Gesellschafter oder von einem Anwalt, Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer
unter der Berufsverschwiegenheitspflicht begleitet oder vertreten zu werden.
13.5 Eine Niederschrift hinsichtlich des Ablaufs der Versammlung ist (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die
Wirksamkeit) anzufertigen und hat den Ort und das Datum der Versammlung, die Teilnehmer, die Tagesordnungspunkte,
den Hauptinhalt der Verhandlungen und die Gesellschafterbeschlüsse zu beinhalten, es sei denn, die Verhandlungen der
Gesellschafterversammlung wurden notariell beurkundet. Die Niederschrift ist von allen bei der Gesellschafterversamm-
lung anwesenden oder vertretenen Gesellschaftern zu unterzeichnen (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die
Wirksamkeit). Jedem Gesellschafter ist eine Kopie der Niederschrift zuzusenden.
Art. 14. Quorum und Abstimmung.
14.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.
14.2 Eine Gesellschafterversammlung ist nur dann beschlussfähig, wenn mindestens fünfzig Prozent (50%) des Gesell-
schaftskapitals vertreten sind. Vorbehaltlich anderer Regelungen dieser Satzung oder des Gesetzes von 1915, die ein
höheres Mehrheitsverhältnis vorsehen, bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von
Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals innehaben. Bei Beschlussunfähigkeit ist unverzüglich im
Einklang mit Artikel 13.2 eine neue Gesellschafterversammlung mit derselben Tagesordnung einzuberufen. Diese Gesell-
schafterversammlung ist dann unabhängig von dem vertretenen Gesellschaftskapital beschlussfähig, sofern darauf in der
die Versammlung einberufenden Ladung hingewiesen wurde und Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen
Stimmen gefasst.
Art. 15. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.
Art. 16. Änderung der Satzung. Eine Änderung dieser Satzung erfordert die Zustimmung (i) einer zahlenmäßigen
Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die gleichzeitig eine Qualifizierte Mehrheit darstellen.
Art. 17. Beschlüsse, die eine spezifische Mehrheit erfordern.
17.1 Gesellschafterbeschlüsse hinsichtlich der folgenden Angelegenheiten erfordern eine Qualifizierte Mehrheit:
126125
L
U X E M B O U R G
17.1.1 Veräußerung des gesamten Gesellschaftsvermögens oder eines beträchtlichen Anteils des Gesellschaftsvermö-
gens einschließlich des Beschlusses hinsichtlich der Liquidation der Gesellschaft;
17.1.2 Beschluss hinsichtlich der Verschmelzung, Ausgliederung und Umwandlung der Gesellschaft;
17.1.3 Abschluss von Unternehmensverträgen (im Sinne der §§ 291 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG));
17.1.4 Abschluss von Unternehmensbeteiligungen (um Zweifel auszuschließen, nicht durch die Veräußerung von An-
teilen) jeglicher Art einschließlich stiller Beteiligungen und sämtlicher Verträge, durch welche die andere Vertragspartei
eine Beteiligung am Gewinn der Gesellschaft erhält oder jede Zahlung, welche vom Gewinnbetrag der Gesellschaft ab-
hängig ist; dies umfasst nicht Verträge mit Gesellschaftern oder Angestellten der Gesellschaft, einschließlich Verträge,
welche im Hinblick auf einen voraussichtlichen Status als Gesellschafter oder Angestellter abgeschlossen wurden, sowie
Verträge mit Dritten innerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs, z.B. Verträge zwischen der Gesellschaft und Werbe-
partnern.
17.2 Beschlüsse hinsichtlich der folgenden Angelegenheiten erfordern eine Qualifizierte Mehrheit und zudem die vor-
herige Zustimmung der Investoren.
17.2.1 Ausschluss von Bezugsrechten im Falle von Kapitalerhöhungen;
17.2.2 Erwerb eigener Anteile der Gesellschaft, mit Ausnahme der Erwerbe gemäß Artikel 9.2 und Übertragungen
gemäß Artikel 11.1 dieser Satzung.
17.3 Ist das Gesellschaftskapital in verschiedene Anteilsklassen unterteilt, so können die spezifischen Rechte und
Pflichten im Zusammenhang mit einer Anteilsklasse mit der einstimmigen und schriftlichen Zustimmung der Gesellschaf-
ter, die alle ausgegebenen Anteile dieser Anteilsklasse halten, verändert oder aufgehoben werden.
D. Rat der Geschäftsführer - Beirat
Art. 18. Befugnisse des Alleinigen Geschäftsführers - Zusammensetzung und Befugnisse des Rates der Geschäftsführer.
18.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Ge-
schäftsführer hat, bilden diese einen Rat der Geschäftsführer.
18.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „alleiniger Ge-
schäftsführer“ nicht ausdrücklich in dieser Satzung verwendet wird, ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Rat der
Geschäftsführer“ als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer“ auszulegen.
18.3 Der Rat der Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, im Namen der Gesellschaft zu handeln
und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.
Art. 19. Ernennung, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
19.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung ernannt, welche ihre Bezüge und
ihre Amtszeit festlegt.
19.2 Die Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund ernannt oder abberufen werden.
19.3 Die Gesellschafterversammlung kann die Ernennung von Geschäftsführern zwei (2) unterschiedlicher Kategorien
beschließen, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Eine solche Klassifizierung
der Geschäftsführer muss ordnungsgemäß in der Niederschrift des betreffenden Gesellschafterbeschlusses festgehalten
und die Geschäftsführer der Kategorie, der sie angehören, zugeordnet werden.
Art. 20. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
20.1 Scheidet ein Geschäftsführer durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Insolvenz, Rücktritt oder aus einem anderem
Grund aus seinem Amt aus, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen
die ursprüngliche Amtszeit des ersetzten Geschäftsführers nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesell-
schafterversammlung ausgefüllt werden, welche im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die
endgültige Ernennung entscheidet.
20.2 Für den Fall, dass der alleinige Geschäftsführer aus seinem Amt ausscheidet, muss die frei gewordene Stelle
unverzüglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.
Art. 21 Einladung zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
21.1 Der Rat der Geschäftsführer versammelt sich auf Einberufung durch einen Geschäftsführer. Die Sitzungen des
Rates der Geschäftsführer finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.
21.2 Die Geschäftsführer werden mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung anberaumten
Zeitpunkt zu jeder Sitzung des Rates der Geschäftsführer schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe
der Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Geschäftsführer
per Post, Fax, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abgegeben haben, wobei
eine Kopie eines solchen Dokuments ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung zu Sitzungen des Rates der Ge-
schäftsführer ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss des Rates der Geschäftsführer
bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.
126126
L
U X E M B O U R G
21.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle
Einladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Rates
der Geschäftsführer diesen zustimmen und diese unterzeichnen.
Art. 22. Geschäftsführung.
22.1 Der Rat der Geschäftsführer kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Rat der Ge-
schäftsführer kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise selbst ein Geschäftsführer sein muss
und der für die Protokollführung der Sitzungen des Rates der Geschäftsführer verantwortlich ist.
22.2 Sitzungen des Rates der Geschäftsführer werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Rates der Ge-
schäftsführer geleitet. In dessen Abwesenheit kann der Rat der Geschäftsführer einen anderen Geschäftsführer durch
einen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Mitglieder als Vorsitzenden pro tempore ernennen.
22.3 Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer teilnehmen, indem er einen anderen
Geschäftsführer schriftlich oder durch Faxschreiben, per E-Mail oder durch ein anderes vergleichbares Kommunikati-
onsmittel bevollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Geschäftsführer
kann einen oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.
22.4 Eine Sitzung des Rates der Geschäftsführer kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein
anderes Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu
hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel
ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung gilt als am Sitz der Ge-
sellschaft abgehalten.
22.5 Der Rat der Geschäftsführer kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest eine Mehrheit der
Geschäftsführer in einer Sitzung anwesend oder vertreten ist.
22.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Rates der Geschäftsführer
teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden,
hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme. Sofern die Gesellschafterversammlung allerdings un-
terschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäfts-
führer der Kategorie B), werden Beschlüsse des Rates der Geschäftsführer nur dann wirksam gefasst, wenn sie von der
Mehrheit der Geschäftsführer einschließlich mindestens eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsfüh-
rers der Kategorie B (oder deren Vertreter) gefasst werden.
22.7 Der Rat der Geschäftsführer kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung,
per Faxschreiben, oder per E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Jeder Geschäftsführer
kann seine Zustimmung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des
betreffenden Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Be-
schlusses.
22.8 Die Geschäftsführer benötigen die Zustimmung von mindestens zwei (2) der Gesellschafter Rocket, Holtzbrinck,
Access, TJT, DZ und Aismare, die zum gegebenen Zeitpunkt gemeinsam mehr als fünfzig Prozent (50%) des eingetragenen
Gesellschaftskapitals der Gesellschaft halten (die „Mehrheit der Investoren“) für die unten genannten Rechtsgeschäfte
und Maßnahmen. Eine Zustimmung ist nicht erforderlich, sofern solche Rechtsgeschäfte und Maßnahmen präzise definiert
und im Voraus von einem bewilligten Haushaltsplan mit der Zustimmung der Mehrheit der Investoren genehmigt wurden:
22.8.1 Gründung, Erwerb, Schließung oder Veräußerung von Unternehmen oder Teilbetrieben;
22.8.2 Änderung der Statuten, dieser Satzung, Gesellschaftervereinbarungen und ähnlicher Verträge, sowie die Aus-
übung (oder der Ausschluss) von Gesellschafterrechten bei Gesellschaften, in denen eine Beteiligung gehalten wird;
22.8.3 Erwerb, Verkauf und Belastung von Immobilien und ähnlichen Rechten oder Rechten an Immobilien;
22.8.4 Gründung, Verlegung und Schließung von Filialen und Niederlassungen;
22.8.5 Änderung der Geschäftsfelder der Gesellschaft und Aufgabe bestehender und Aufnahme neuer Geschäftsfelder;
22.8.6 Genehmigung des Jahresplans, insbesondere des Haushaltsplans für jedes folgende Jahr;
22.8.7 Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder ähnlichen Verpflichtungen, die einen Gesamtbetrag von zwei-
hunderttausend Euro (EUR 200.000,00) überschreiten;
22.8.8 Gewährung von Darlehen, die, im Einzelfall, einen Betrag von zweihunderttausend Euro (EUR 200.000,00)
überschreiten, allerdings unter Ausschluss von Darlehen zwischen der Gesellschaft und direkten oder indirekten Toch-
tergesellschaften der Gesellschaft;
22.8.9 Abschluss und Kündigung von Kredit- und Darlehensverträgen und anderen Finanzverträgen, die, im Einzelfall,
einen Betrag von zweihunderttausend Euro (EUR 200.000,00) überschreiten und Änderungen des Kreditrahmens und
außerordentliche Rückzahlungen, allerdings unter Ausschluss von Verträgen zwischen der Gesellschaft und direkten oder
indirekten Tochtergesellschaften der Gesellschaft;
22.8.10 Termingeschäfte über Devisen, Sicherheiten und börsengehandelte Waren und Rechte, sowie weitere Trans-
aktionen mit derivaten Finanzinstrumenten;
22.8.11 Gewährung, Einführung und Änderung von Versorgungsverpflichtungen jeglicher Art;
126127
L
U X E M B O U R G
22.8.12 Abschluss, Änderung und Auflösung von Arbeitsverträgen, die eine Vergütung von einhundertfünfzigtausend
Euro (EUR 150.000,00) pro Jahr überschreiten;
22.8.13 Zusicherung oder Gewährung von Sonderzulagen und Gratifikationen jeglicher Art außerhalb bestehender
Arbeitsverträge, sowie Zahlung von Vorschüssen oder Gewährung von Darlehen an Geschäftsführer und Angestellte,
die, im Einzelfall, einen Betrag von fünfzigtausend Euro (EUR 50.000,00) überschreiten;
22.8.14 Abschluss, Änderung oder Kündigung von Unternehmenstarifverträgen, Betriebsvereinbarungen (von erheb-
licher Bedeutung) und allgemeiner Richtlinien hinsichtlich der betrieblichen Altersvorsorge der Gesellschaft;
22.8.15 Einleitung oder Beendigung von Rechtsstreitigkeiten, insbesondere Schiedsgerichtverfahren mit einem Streit-
wert von über zehntausend Euro (EUR 10.000,00) im Einzelfall;
22.8.16 Erwerb, Verfügung und/oder Lizenzierung von Nutzungsrechten jeglicher Art hinsichtlich der Rechte an geist-
igem Eigentum, einschließlich Urheberrechte oder sämtliche weiteren Schutzrechte, sowie die Weitergabe von Know-
how zur eigenen Verwertung durch die Firma und/oder Drittparteien, sowie die Erteilung oder der Erwerb von Lizenzen
und die Abänderung diesbezüglicher Verträge, jedoch unter Ausschluss von Verfügungen zwischen der Gesellschaft und
direkten und indirekten Tochtergesellschaften der Gesellschaft;
22.8.17 Erteilung einer Vollmacht, durch welche ein Bevollmächtigter einen anderen Bevollmächtigten dazu ermächtigt,
auf Kosten der Gesellschaft einen Vertrag mit diesem zu schließen;
22.8.18 Transaktionen der Gesellschaft und ihrer Investoren mit verbundenen juristischen und natürlichen Personen.
Als solche werden angesehen direkte oder indirekte Gesellschafter der Gesellschaft (einschließlich, zur Klarstellung,
European Founders Fund GmbH („EFF“) und EFF’s direkte und indirekte Gesellschafter (z.B. die Samwer Brüder), aber
ausschließlich direkter oder indirekter Gesellschafter von Holtzbrinck und/oder Access und/oder TJT und/oder DZ und/
oder Aismare), verbundene Gesellschaften gemäß §§ 15 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG), sowie Angehörige
direkter oder indirekter Gesellschafter gemäß Abschnitt 15 der deutschen Abgabenordnung (AO), sofern letztere (mit
Ausnahme von EFF und EFF’s direkter und indirekter Gesellschafter) - einzeln oder gemeinsam - direkt oder indirekt eine
Mehrheitsbeteiligung halten. Die Zustimmung gemäß dieses Artikels 22.8.18 ist nicht erforderlich, wenn die Transaktion
zum gewöhnlichen Geschäftsgang der Gesellschaft gehört und marktüblichen Bedingungen unterliegt;
22.8.19 Änderung der Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft;
22.8.20 Gewährung, Schaffung oder Änderung eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms (einschließlich der Gewährung
jeglicher Aktienoptionen) außerhalb der bestehenden vereinfachten Mitarbeiterbeteiligung, die zwischen den Gesellschaf-
tern in einer Gesellschaftervereinbarung vereinbart wurde;
22.8.21 Ausübung von Stimmrechten und anderen Rechten in einer Gesellschaft, deren Gesellschafter die Gesellschaft
ist, sofern diese Ausübung, wenn die Gesellschaft betroffen wäre, die Zustimmung der Mehrheit der Investoren nach
dieser Satzung erfordern würde, d.h. gemäß dieses Artikels 22.8 oder Artikels 17.
22.9 Ist die Zustimmung zum Erwerb, zum Verkauf oder zur Belastung von Objekten wie oben beschrieben erforder-
lich, so ist die Zustimmung ebenfalls für die damit verbundenen vertraglichen Verpflichtungen erforderlich. Die Gesell-
schafterversammlung kann durch einen Beschluss weitere Transaktionen und Maßnahmen bestimmen, die die Zustimmung
der Mehrheit der Investoren erfordern. Die Mehrheit der Investoren kann ihre Zustimmung für bestimmte Gruppen und
Arten von Transaktionen und Maßnahmen auch im Voraus erteilen.
22.10 Die Gesellschafter können durch einen Gesellschafterbeschluss eine Geschäftsordnung für die Geschäftsführer
beschließen.
22.11 Die Geschäftsführung hat sicherzustellen, dass die Bestimmungen dieses Artikels 22, soweit gesetzlich möglich,
auf die gleiche Weise auf sämtliche verbundenen Gesellschaften angewendet werden, in welchen die Gesellschaft direkt
oder indirekt gegenwärtig oder künftig eine Mehrheitsbeteiligung hält.
Art. 23. Protokoll von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer; Protokoll der Entscheidungen des Alleinigen Ge-
schäftsführers.
23.1 Das Protokoll einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer wird vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer,
falls vorhanden oder, im Falle seiner Abwesenheit, vom Vorsitzenden pro tempore und dem Schriftführer (falls vorhan-
den), oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unterschied-
liche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der
Kategorie B), werden Protokolle von einem (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einem (1) Geschäftsführer der
Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsver-
fahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer, falls
vorhanden, oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden solche Kopien oder Auszüge von einem (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einem (1)
Geschäftsführer der Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet.
23.2 Die Entscheidungen des alleinigen Geschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom alleinigen
Geschäftsführer unterzeichnet wird. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet.
126128
L
U X E M B O U R G
Art. 24. Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Um-
ständen (i) durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder, für den Fall, dass die Gesellschaft mehrere
Geschäftsführer hat, durch die gemeinsamen Unterschriften zwei (2) beliebiger Geschäftsführer wirksam verpflichtet;
sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäfts-
führer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B), wird die Gesellschaft nur durch die gemeinsamen
Unterschriften mindestens eines (1) Geschäftsführers der Kategorie A und eines (1) Geschäftsführers der Kategorie B
(oder deren Vertreter), oder (ii) durch die gemeinsamen Unterschriften oder die alleinige Unterschrift jedweder Person
(en), der/denen eine Unterschriftsbefugnis durch den Rat der Geschäftsführer übertragen worden ist, wirksam verpflich-
tet.
Art. 25. Beirat.
25.1 Die Gesellschaft hat einen Beirat. Dieser besteht aus sieben (7) stimmberechtigten Mitgliedern. Die Gesellschaf-
terversammlung kann durch einen Gesellschafterbeschluss die Anzahl der stimmberechtigten Mitglieder des Beirats
erhöhen oder herabsetzen.
25.2 Die Gesellschafterversammlung kann die Geschäftsordnung für den Beirat nur durch einen einstimmigen Gesell-
schafterbeschluss festlegen und/oder verändern.
25.3 Die stimmberechtigten Mitglieder des Beirats werden von dem ernennenden Gesellschafter jedes entsprechenden
Mitglieds durch schriftliche Mitteilung an die Gesellschaft wie folgt ernannt, abberufen oder ersetzt:
25.3.1 Vier (4) stimmberechtigte Mitglieder des Beirats werden von dem Gesellschafter Rocket nach eigenem Ermessen
ernannt;
25.3.2 Ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats wird von dem Gesellschafter Holtzbrinck nach eigenem Ermessen
ernannt;
25.3.3 Ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats wird von dem Gesellschafter Access nach eigenem Ermessen
ernannt; und 25.3.4 Ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats wird von dem Gesellschafter Aismare nach eigenem
Ermessen ernannt.
25.4 Der Beirat kann nicht-stimmberechtigte Mitglieder als Beobachter haben.
25.5 Der Beirat hat einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden. Ein von Rocket ernanntes stimm-
berechtigtes Mitglied ist der Vorsitzende des Beirats. Die Geschäftsordnung des Beirats hat weitere Bestimmungen,
insbesondere hinsichtlich der Selbstorganisation des Beirats, zu enthalten. Der Beirat fasst Beschlüsse mit einfacher
Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Der Beirat hält regelmäßig Sitzungen ab, mindestens einmal pro Kalenderquartal.
25.6 Der Beirat ist für die Beratung der Geschäftsführer der Gesellschaft hinsichtlich Strategie und operativer Ange-
legenheiten zuständig und berät mit den Geschäftsführern über den Haushalt der Gesellschaft.
25.7 Der Beirat ist kein Aufsichtsrat im Sinne des Artikels 60bis-11 ff. des Gesetzes von 1915.
E. Aufsicht und Prüfung der Gesellschaft
Art. 26. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
26.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der
Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)). Die Gesellschafterversammlung
ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.
26.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
26.3 Die Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Recht der permanenten Überprüfung und Kontrolle aller Ge-
schäfte der Gesellschaft.
26.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember
2002 betreffend das Handelsregister und die Buchhaltung und den Jahresabschluss von Unternehmen, in der jeweils
gültigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d’entreprises agréé(s)) ernennen, entfällt
die Funktion des Rechnungsprüfers.
26.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die
Gesellschafterversammlung abberufen werden.
F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss -Gewinnverwendung - Abschlagsdividenden
Art. 27. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am
einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.
Art. 28. Jahresabschluss und Gewinne.
28.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Rat der Geschäftsführer erstellt im
Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und
Verlustrechnung.
28.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage
der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.
126129
L
U X E M B O U R G
28.3 Durch einen Gesellschafter erbrachte Einlagen in Rücklagen können mit Zustimmung dieses Gesellschafters
ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.
28.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage der Gesellschaft verhältnis-
mäßig herabgesetzt werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.
28.5 Auf Vorschlag des Rates der Geschäftsführer bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den Be-
stimmungen des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung, wie der verbleibende jährliche Nettogewinn der Gesellschaft
verwendet werden soll.
28.6 Vorbehaltlich des Artikels 8 erfolgen Ausschüttungen an die Gesellschafter proportional zur Anzahl der von ihnen
an der Gesellschaft gehaltenen Anteile.
Art. 29. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
29.1 Der Rat der Geschäftsführer kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche
vom Rat der Geschäftsführer vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur
Verfügung stehen. Der ausschüttbare Betrag wird gegebenenfalls im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 8 verteilt
und darf nicht die Summe der seit dem Ende des vergangenen Geschäftsjahres angefallenen Gewinne, gegebenenfalls
erhöht durch vorgetragene Gewinne und ausschüttbare Rücklagen, beziehungsweise vermindert durch vorgetragene
Verluste und Summen, die einer Rücklage zugeführt werden, welche nach dem Gesetz von 1915 oder dieser Satzung nicht
ausgeschüttet werden darf, übersteigen.
29.2 Das Agio, andere Kapitalreserven oder andere ausschüttbare Rücklagen können im Einklang mit den Bestimmun-
gen des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.
G. Liquidation
Art. 30. Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Liqui-
dation durch einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden,
die über die Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit
nichts anderes bestimmt wird, haben die Liquidatoren die weitestgehenden Befugnisse für die Verwertung der Vermö-
genswerte und die Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
H. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht
Art. 31 Anwendbares Recht.
31.1 Sämtliche in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten unterliegen den Bestimmungen des Gesetzes von
1915 und jeder Gesellschaftervereinbarung, die die Gesellschafter mitunter mit der Gesellschaft eingehen und durch die
bestimmte Bestimmungen dieser Satzung ergänzt werden könnten. Sollte ein Artikel dieser Satzung mit den Bestimmungen
einer Gesellschaftervereinbarung in Widerspruch stehen, so ist die Gesellschaftervereinbarung zwischen den Parteien,
soweit nach luxemburgischem Recht zulässig, maßgebend.
31.2 Diese Satzung wurde auf Englisch verfasst, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; im Falle von Abweichungen
zwischen der englischen und der deutschen Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.“
Da die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung geschlossen.
<i>Kosten und Auslageni>
Die Kosten, Auslagen, Honorare und Gebühren jeglicher Art, die von der Gesellschaft zu tragen sind, werden auf
ungefähr eintausendvierhundert Euro (EUR 1.400) geschätzt.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache beherrscht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende
Urkunde auf Verlangen der erschienenen Parteien auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung;
auf Verlangen besagter erschienener Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen
Fassung, ist die englische Fassung maßgebend
WORÜBER, wurde diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen.
Die vorstehende Urkunde ist dem Bevollmächtigten der erschienenen Parteien, welcher dem Notar mit Namen,
Vornamen und Wohnsitz bekannt ist, verlesen und vom Notar gemeinsam mit diesem Bevollmächtigten unterzeichnet
worden.
Signé: L. AGUERRE ENRIQUEZ, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 8 juillet 2014. LAC/2014/31763. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
Luxembourg, le 18 juillet 2014.
Référence de publication: 2014106568/1267.
(140127336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.
126130
L
U X E M B O U R G
Weldiflex, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9656 Harlange, 20B, rue Bierg.
R.C.S. Luxembourg B 175.092.
L'an deux mille quatorze, le trente juin.
Pardevant Maître Martine WEINANDY, notaire de résidence à Clervaux.
a comparu:
Monsieur Guy BODSON, ingénieur, né à Verviers (B), le 5 février 1969, demeurant à L-8824 Perlé, 14 rue du Faubourg,
seul et unique associé de la société à responsabilité limitée «WELDIFLEX» (20132403539), établie et ayant son siège
social à L-8824 Perlé, 14, rue du Faubourg, RCS B175092,
constituée suivant acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg agissant en remplace-
ment de son confrère empêché Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster en date du 30 janvier 2013,
publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Numéro 798 du 4 avril 2013.
L'associé unique a ensuite abordé l'ordre du jour et a pris la résolution suivante à l'unanimité des voix:
<i>Première et unique résolutioni>
Le siège social de la société est transféré de L-8824 Perlé, 14, rue du Faubourg à L-9656 Harlange, 20B, rue Bierg et
le premier alinéa de l'article 5 des statuts est modifié pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 5 al.1. Le siège social est établi dans la commune de Lac de la Haute-Sûre».
Le reste de l'article 5 reste inchangé.
L'adresse de la société est à L-9656 Harlange, 20B, rue Bierg.
Tous les frais et honoraires du présent acte incombent à la société.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée.
DONT ACTE Fait et passé à Clervaux, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée comparants, tous connus du notaire instrumentaire par nom, prénom
usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Bodson, Martine Weinandy.
Enregistré à Clervaux, le 02 juillet 2014. Relation: CLE/2014/676. Reçu soixante-quinze euros (75,00€).
<i>Le Receveuri> (signé): Rodenbour C.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt aux firmes.
Clervaux, le 04 juillet 2014.
Martine WEINANDY.
Référence de publication: 2014106273/33.
(140127501) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2014.
Sarasino Soparfi S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7651 Heffingen, 8, Hannert der Kiirch.
R.C.S. Luxembourg B 129.744.
L'an deux mille quatorze.
Le seize juillet.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).
S'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SARASINO SOPARFI S.A., avec siège social
à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le
numéro B 129.744 (NIN 2007 2220 472),
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 12 juillet 2007, publié au Mémorial C Recueil des
Sociétés et Associations numéro 1826 du 29 août 2007, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le
notaire instrumentant en date du 18 juillet 2013, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 2239
du 12 septembre 2013,
au capital social de trente-et-un mille Euros (€ 31.000.-), représenté par deux cents (200) actions d'une valeur nominale
de cent cinquante-cinq Euros (€ 155.-) chacune, entièrement libérées.
L'assemblée est présidée par Madame Peggy SIMON, employée privée, demeurant professionnellement à Echternach,
9, Rabatt,
126131
L
U X E M B O U R G
qui se nomme elle-même comme scrutateur et qui désigne comme secrétaire Madame Mariette SCHOU, employée
privée, demeurant professionnellement à Echternach, 9, Rabatt.
Le bureau étant ainsi constitué, Madame le Président expose et prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre des actions détenues par chacun d'eux ressortent d'une liste
de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant, et qui restera annexée au
présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
II.- Il résulte de cette liste de présence que les deux cents (200) actions d'une valeur nominale de cent cinquante-cinq
Euros (€ 155.-) chacune, représentant l'intégralité du capital souscrit sont présentes ou représentées à la présente as-
semblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut valablement délibérer sur tous les points de l'ordre du
jour.
III.- L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:
1.- Transfert du siège social et fixation de la nouvelle adresse à L-7651 Heffingen, 8, Hannert der Kiirch.
2.- Modification du premier alinéa de l'article 2 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:
" Art. 2. (alinéa 1
er
). Le siège social est établi à Heffingen."
Après approbation de ce qui précède par l'assemblée générale, celle-ci prend à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale décide de transférer le siège de la société de Luxembourg à Heffingen et de fixer la nouvelle
adresse à L-7651 Heffingen, 8, Hannert der Kiirch.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l'article 2 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:
" Art. 2. (alinéa 1
er
). Le siège social est établi à Heffingen."
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Echternach, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, qui sont tous connus du notaire par noms, prénoms,
états et demeures, ils ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: P. SIMON, M. SCHOU, Henry. BECK.
Enregistré à Echternach, le 17 juillet 2014. Relation: ECH/2014/1327. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): J.-M. MINY.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Echternach, le 18 juillet 2014.
Référence de publication: 2014106104/52.
(140126288) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2014.
Bärlu S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 36-38, Grand-Rue.
R.C.S. Luxembourg B 130.578.
Im Jahre zwei tausend und vierzehn, den siebten Juli.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph ELVINGER, mit Amtssitz zu Luxemburg.
Traten die Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung "BÄRLU S.à R.L.", mit Sitz zu L-7270 Helmsange,
13, Rue des Nations Unies, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammen;
genannte Gesellschaft, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister zu Luxemburg, Sektion B unter Nummer
130.578, wurde gegründet durch Urkunde vom 13. Juli 2007, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 2062 vom 21.
September 2007.
Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Frau Rachel UHL, Juristin, wohnhaft in Luxemburg.
Die Vorsitzende bezeichnet zum Schriftführer und die Generalversammlung wählt zum Stimmzähler Herrn Andreas
DEGENHARDT, Geschäftsführer, wohnhaft in Helmsange.
Die Vorsitzende erklärt die Sitzung eröffnet und gibt folgende Erklärungen ab, welche von dem amtierenden Notar zu
Protokoll genommen werden.
A.- Dass aus einer vom Versammlungsvorstand erstellten Anwesenheitsliste hervorgeht, dass sämtliche Gesellschafter
in gegenwärtiger Versammlung zugegen oder rechtlich vertreten sind; diese Anwesenheitsliste, von den Gesellschaftern
respektiv deren Vertretern gegengezeichnet und von dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt gegen-
wärtiger Urkunde beigebogen um mit derselben einregistriert zu werden, ebenso wie die ordnungsgemäss durch die
Erschienenen und den amtierenden Notar ne varietur paraphierten Vollmachten der vertretenen Aktionäre.
126132
L
U X E M B O U R G
B.- Dass die Generalversammlung, in Anbetracht der Anwesenheit respektiv Vertretung sämtlicher Gesellschafter,
regelmässig zusammengesetzt ist und gültig über alle Punkte der Tagesordnung beschliessen kann.
C.- Dass die Tagesordnung folgende Punkte vorsieht:
<i>Tagesordnungi>
1) Sitzverlegung von L-7270 Helmsange, 13, Rue des Nations Unies nach L-1660 Luxembourg, 36-38, Grand-Rue.
2) Änderung von Artikel 4, erster Absatz.
Nach Diskussion, nimmt die Generalversammlung einstimmig und über jeden Punkt einzeln folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst den Gesellschaftsitz von -7270 Helmsange, 13, Rue des Nations Unies nach
L-1660 Luxembourg, 36-38, Grand-Rue, zu verlegen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Zwecks Anpassung der Satzung an den hiervor genommenen Beschluss, beschliesst die Generalversammlung Artikel
4, erster Absatz, abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
"Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg".
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Herr Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.
WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen zu Luxemburg.
Im Jahre, Monate und am Tage wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung, haben die vorgenannten Komparenten zusammen mit dem amtierenden Notar die vorliegende
Urkunde unterschrieben.
Signé: R. UHL, A. DEGENHARDT, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils le 9 juillet 2014. Relation: LAC/2014/31937. Reçu soixante quinze euros (EUR
75,-).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
Référence de publication: 2014106362/47.
(140127847) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.
Chiapparo G.m.b.h., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5690 Ellange, 2, route de Remich.
R.C.S. Luxembourg B 188.769.
STATUTEN
Im Jahre zweitausendvierzehn, den zehnten Juli.
Vor Maître Paul BETTINGEN Notar, mit Amtssitz in Niederanven,
IST ERSCHIENEN:
Herr Giuseppe CHIAPPARO, Unternehmer, geboren in Merzig (D) am 1. November 1990, wohnhaft in D-66663
Merzig, Lenchen-Weber-Strasse 4, Bundesrepublik Deutschland,
Die oben benannte Partei erklärt ihre Absicht, mit dieser Urkunde eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit nur
einem Gesellschafter zu gründen und die folgende Satzung aufzuzeichnen:
Titel I. - Firma - Sitz - Zweck - Dauer
Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche den bestehenden luxemburgi-
schen Gesetzen und insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, wie abgeändert,
(hiernach das „Gesetz“) und der hiernach folgenden Satzung (die „Satzung“) unterliegt.
Art. 2. Die Gesellschaft führt die Firma “CHIAPPARO G.m.b.H.” (die „Gesellschaft“).
Art. 3. Der Gesellschaftssitz ist in der Gemeinde Mondorf-les-Bains. Er kann auf Grund eines Beschlusses der Gesell-
schafter, welcher nach den gesetzlichen Regelungen, die für eine Satzungsänderung maßgeblich sind, ergeht, an jeden
anderen Ort innerhalb des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.
Im Falle außergewöhnlicher politischer oder wirtschaftlicher Ereignisse, welche auftreten oder sich dringlich ergeben
und die normale Aktivität oder Kommunikation am Gesellschaftssitz mit dem Ausland erschweren, kann der Gesell-
schaftssitz vorübergehend ins Ausland verlegt werden bis diese Ereignisse oder Umstände nicht mehr vorhanden sind.
Eine solche Entscheidung hat keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft. Die Entscheidung wird durch das
Organ der Gesellschaft an Drittparteien bekannt gemacht, welches am besten dafür in der Lage ist.
126133
L
U X E M B O U R G
Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist:
- das Betreiben eines Bauunternehmens in allen Bereichen des Hochund Tiefbaus, sowie Abbruchsarbeiten,
einschließlich Verputz, Malerarbeiten und Baunebentätigkeiten;
- das Ausführen von Erdbewegungsarbeiten, Landschaftsbau sowie Handel mit Pflanzen, Sträuchern, Bäumen, Bewäs-
serungsanlagen, Maschinen, Werkzeugen, Rohstoffen, Material und Produkten.
Die Gesellschaft hat ferner zum Zweck den Erwerb von Grundstücken, sowie die Planung und den Verkauf als Bauträger
von Immobilien.
Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit oder
ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüglichen
gesetzlichen Bestimmungen.
Die Gesellschaft kann außerdem alle anderen Operationen kommerzieller, industrieller, finanzieller, mobiliarer und
immobiliarer Art, welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern, ausfüh-
ren.
Art. 5. Die Gesellschaft ist auf unbeschränkte Dauer gegründet.
Art. 6. Die Gesellschaft wird nicht durch Insolvenz, Zahlungsunfähigkeit oder Verlust der Geschäftsfähigkeit eines
Gesellschafters aufgelöst.
Titel II. - Gesellschaftskapital - Anteile
Art. 7. Das Gesellschaftskapital beträgt ZWÖLFTAUSENDFÜNFHUNDERT EURO (EUR 12.500,-), eingeteilt in
FÜNFHUNDERT (500) Anteile von je FÜNFUNDZWANZIG EURO (EUR 25,-).
Art. 8. Die Anteile können, solange es nur einen Gesellschafter gibt, von diesem Gesellschafter ohne Beschränkungen
übertragen werden.
Im Falle dass es mehrere Gesellschafter gibt, sind die Anteile unter den Gesellschaftern frei übertragbar. Eine Über-
tragung von Anteilen inter vivos an Nichtgesellschafter kann nur nach Zustimmung von Gesellschaftern, welche mindes-
tens drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals vertreten, erfolgen.
Für alle anderen Angelegenheiten wird auf die Artikel 189 und 190 des Gesetzes verwiesen.
Art. 9. Ein Gesellschafter, seine Erben, Vertreter, Berechtigten oder Gläubiger können weder einen Antrag auf Sie-
gelanlegung an den Gütern und Werten der Gesellschaft stellen, noch in irgendeiner Form den normalen Geschäftsgang
der Gesellschaft beeinträchtigen.
Zur Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich auf die Bilanzen und die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung be-
ziehen.
Titel III. - Geschäftsführung
Art. 10. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern, welche von den Gesellschaftern für eine
unbestimmte Dauer gewählt werden, verwaltet. Sofern mehrere Geschäftsführer gewählt sind, bilden sie einen Vorstand.
Die Geschäftsführer können ohne Angabe von Gründen, ad nutum, abgewählt werden.
Der Geschäftsführer oder, im Falle mehrerer Geschäftsführer, der Vorstand ist mit den größtmöglichen Befugnissen
ausgestattet, um alle Handlungen zur Verwaltung und Geschäftstätigkeit der Gesellschaft im Einklang mit dem Gesell-
schaftszweck durchführen zu können, wobei ihm alle Befugnisse zustehen, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder
diese Satzung der Gesellschafterversammlung zugeschrieben werden.
Sollte die Gesellschaft als Klägerin oder Beklagte in einem Rechtsstreit auftreten, vertritt der Geschäftsführer, oder
im Falle des Vorstands der vom Vorstand dafür autorisierte Geschäftsführer, die Gesellschaft in ihrem eigenen Namen.
Im Falle der Ernennung mehrerer Geschäftsführer wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift von zwei
Mitgliedern des Vorstandes rechtswirksam verpflichtet.
Der Geschäftsführer oder, im Falle mehrerer Geschäftsführer, der Vorstand kann seine Zuständigkeiten für spezielle
Aufgaben an Unterbevollmächtigte oder an einen oder mehrere ad hoc Vertreter delegieren.
Im Falle mehrerer Geschäftsführer kann der Vorstand nur wirksam entscheiden, wenn mindestens die Hälfte seiner
Mitglieder anwesend oder vertreten ist.
Beschlüsse des Vorstandes benötigen eine Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer.
Alle Treffen des Vorstandes finden in Luxemburg statt.
Beschlüsse, welche von allen Mitgliedern des Vorstandes unterzeichnet sind, gelten als genauso wirksam angenommen,
als wenn diese Beschlüsse bei einer korrekt einberufenen und abgehaltenen Vorstandssitzung getroffen worden wären.
Die Unterschriften können auf einem einzelnen Dokument oder auf mehreren identischen Kopien erscheinen und sie
können durch Brief, Telefax oder ähnliche Kommunikation nachgewiesen werden.
Außerdem soll jedes Vorstandsmitglied welches an einer Vorstandssitzung durch eine Kommunikationshilfe
(einschließlich Telefon) teilnimmt, welche es den (selbst, durch Vollmacht oder ebenfalls durch eine Kommunikationshilfe)
anwesenden Vorstandsmitgliedern erlaubt, das andere Vorstandsmitglied jederzeit während der Sitzung zu hören und
126134
L
U X E M B O U R G
selbst gehört zu werden, als für diese Vorstandssitzung anwesend gelten und soll bei der Aufstellung des Quorums und
mit seiner Stimme bei Abstimmungen während einer solchen Sitzung berücksichtigt werden.
Sollte ein Beschluss im Wege einer Telefonkonferenz gefasst werden, so soll der Beschluss als in Luxemburg gefasst
gelten, sofern die Telefonkonferenz von Luxemburg aus initiiert wurde.
Titel IV. - Gesellschafterversammlung
Art. 11. Der einzige Gesellschafter ist mit allen Zuständigkeiten ausgestattet, die der Gesellschafterversammlung nach
Abschnitt XII des Gesetzes eingeräumt werden.
Alle Entscheidungen, welche nicht in den Zuständigkeitsbereich des Geschäftsführers oder des Vorstandes fallen, kön-
nen vom Gesellschafter getroffen werden. Jede solche Entscheidung muss schriftlich verfasst, in einem Protokoll
festgehalten und in ein spezielles Register eingetragen werden.
Sollte mehr als ein Gesellschafter existieren, so werden die Beschlüsse der Gesellschafter in der Gesellschafterver-
sammlung gefasst oder durch schriftliche Beratung auf Initiative der Geschäftsführung. Beschlüsse gelten nur als ange-
nommen, wenn Gesellschafter, welche mehr als fünfzig Prozent (50%) des Kapitals vertreten, zugestimmt haben.
Beschlüsse zur Abänderung dieser Satzung werden nur wirksam gefasst, wenn ein solcher Beschluss von drei Viertel
(3/4) der anwesenden oder vertretenen Stimmrechte gefasst wird, wobei mindestens fünfzig Prozent (50%) des existie-
renden Gesellschaftskapitals bei der Gesellschafterversammlung anwesend sein muss, ergänzt durch die Vorschriften des
Gesetzes.
Alle Gesellschafterversammlungen finden in Luxemburg statt.
Jeder Gesellschaftsanteil beinhaltet das Recht zur Abgabe einer Stimme auf jeder Gesellschafterversammlung.
Jeder Gesellschafter kann im Wege einer schriftlichen Vollmacht eine andere Person, die kein Gesellschafter sein muss,
bevollmächtigen, ihn auf einer Gesellschafterversammlung zu vertreten und in seinem Namen und auf seine Rechnung
abzustimmen.
Titel IV. - Geschäftsjahr - Gewinn - Reserven
Art. 12. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember desselben Jahres.
Art. 13. Jedes Jahr, am letzten Tag des Monats Dezember, werden ein Inventar der Aktiva und Verpflichtungen der
Gesellschaft, sowie eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung erstellt.
Das Einkommen der Gesellschaft, nach Abzug der generellen Ausgaben und der Unkosten, der Abschreibungen und
der Provisionen, stellt den Nettogewinn dar.
Fünf Prozent (5%) des Nettogewinns werden dem gesetzlichen Reservefonds zugeführt; dieser Abzug ist solange ob-
ligatorisch, bis der Reservefonds zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals umfasst. Der Abzug muss allerdings wieder
bis zur vollständigen Herstellung des Reservefonds aufgenommen werden, wenn der Fonds, zu welchem Zeitpunkt und
aus welchem Grund auch immer, vermindert wurde.
Der verbleibende Betrag des Nettogewinns steht der Gesellschafterversammlung zur Verfügung.
Titel VI. - Liquidation - Auflösung
Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren Liquidator(en) ausge-
führt, welche(r) kein(e) Gesellschafter sein muss(müssen) und welche(r) von der Gesellschafterversammlung, mit der in
Artikel 142 des Gesetzes bestimmten Mehrheit, ernannt wird(werden). Der(die) Liquidator(en) verfügt(verfügen) über
die weitestgehenden Befugnisse zur Realisierung des existierenden Vermögens und Begleichung der Verpflichtungen.
Der nach der Begleichung aller Kosten, Schulden und Ausgaben, welche aufgrund der Liquidation entstehen, zur Ver-
fügung stehende Betrag soll verwendet werden, um die von den Gesellschaftern auf Gesellschaftsanteile eingezahlten
Beträge zurückzuzahlen.
Der danach noch bestehende Restbetrag wird an die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Gesellschaftsbeteiligung aus-
gezahlt.
Titel VII. - Verschiedenes
Art. 15. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Parteien auf die bestehenden gesetz-
lichen Bestimmungen.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2014.
<i>Zeichnungi>
Nachdem diese Satzung wie oben stehend verfasst wurde, erklärt die erschienene Partei, wie folgt Anteile der Ge-
sellschaft zu zeichnen:
Herr Giuseppe CHIAPPARO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Anteile
GESAMT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Anteile
126135
L
U X E M B O U R G
Die Anteile wurden vollständig bis zu einem Betrag von FÜNFUNDZWANZIG EURO (EUR 25,-) je Anteil durch
Barzahlung in Höhe von ZWÖLFTAUSENDFÜNFHUNDERT EURO (EUR 12.500,-) eingezahlt.
Als Ergebnis steht ab dem jetzigen Zeitpunkt der Gesellschaft der Betrag von ZWÖLFTAUSENDFÜNFHUNDERT
EURO (EUR 12.500,-) zur Verfügung, was von dem Notar, welcher diese Urkunde unterzeichnet, bestätigt wird.
<i>Bevollmächtigungi>
Der Erschienene erteilt hiermit einem jeden Angestellten des unterzeichneten Notars Spezialvollmacht, in seinem
Namen jegliche etwaige Berichtigungsurkunde gegenwärtiger Urkunde aufzunehmen.
<i>Kosteni>
Die aufgrund dieser Gründung angefallenen Ausgaben, Kosten, Entschädigungen oder Gebühren jeglicher Form, welche
durch die Gesellschaft zu begleichen sind, werden auf ungefähr eintausendeinhundert Euro (EUR 1.100.-) geschätzt.
<i>Beschlüsse des Alleinigen Gesellschaftersi>
Nachdem diese Satzung soeben verabschiedet wurde, fasst der oben erwähnte einzige Gesellschafter folgende Bes-
chlüsse:
1) Der Sitz der Gesellschaft ist in L-5690 Ellange, 2, route de Remich.
2) Als Geschäftsführer (gérants) der Gesellschaft für eine unbestimmte Dauer werden folgende Personen ernannt:
- Herr Giuseppe CHIAPPARO, Unternehmer, geboren in Merzig (D) am 1. November 1990, wohnhaft in D-66663
Merzig, Lenchen-Weber-Strasse, 4, Bundesrepublik Deutschland (gérant administratif); und
- Herr Hans Peter Michael OPALA, Maurer und Betonbauer, geboren in Diefflen J. Dillingen/Saar (D) am 09. Oktober
1956, wohnhaft in D-66763 Dillingen/Saar, Im Rosengarten 5, Bundesrepublik Deutschland (gérant technique).
Der Notar hat den Erschienenen darauf aufmerksam gemacht, dass eine Handelsermächtigung in Bezug auf den Ge-
sellschaftszweck, ausgestellt durch die luxemburgischen Behörden, vor der Aufnahme jeder kommerzieller Tätigkeit
erforderlich ist, was der Erschienene ausdrücklich anerkennt.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Senningerberg, Datum wie am Anfang dieser Urkunde erwähnt.
Nachdem diese Urkunde der anwesenden Person, welche dem unterzeichnenden Notar durch Name, Vorname, Fa-
milienstand und Anschrift bekannt ist, vorgelesen wurde, hat die anwesende Person zusammen mit dem Notar diese
Urkunde unterzeichnet.
Gezeichnet: Guiseppe Chiapparo, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 11 juillet 2014. LAC / 2014 / 32656. Reçu 75.-€.
<i>Le Receveuri>
(signé): Irène Thill.
- Für gleichlautende Kopie - Ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, den 16. Juli 2014.
Référence de publication: 2014106466/167.
(140127733) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.
Solanis S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R.C.S. Luxembourg B 148.648.
L'an deux mille quatorze, le quatre juillet.
Par-devant Maître Jean-Paul MEYERS, notaire de résidence à Rambrouch, Grand-Duché de Luxembourg,
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "Solanis S.A.", ayant son siège social à
L-7243 Bereldange, 66, rue du Dix Octobre, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le
numéro B 109.469, constituée suivant acte de Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage, en date du 1
er
octobre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2153 du 4 novembre 2009 (la «So-
ciété»).
L’Assemblée est présidée par M. Nico ROLLINGER ayant son adresse professionnelle à Luxembourg (le «Président»).
Le Président nomme Wei Zhang ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, comme secrétaire de l’Assemblée
(le «Secrétaire»).
L’Assemblée élit Philippe Wasila ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, comme scrutateur de l’Assemblée
(le «Scrutateur»).
(Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur étant collectivement appelé le «Bureau»).
Le Bureau ayant été constitué, le Président a déclaré et a requis le notaire d’acter que:
126136
L
U X E M B O U R G
I. Les actionnaires présents ou représentés à l’Assemblée et le nombre des actions détenues par eux sont répertoriés
sur la liste de présence. Cette liste de présence et les procurations des actionnaires représentés, signées ne varietur, par
le Bureau et les mandataires, resteront jointes à ce procès-verbal.
II. Il apparaît selon la liste de présence l’intégralité du capital social étant présente à la présente assemblée, il a pu être
fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
I. L’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
1. Transfert de siège
2. Changement de mandataires
3. Divers.
Ces faits ayant été exposés et reconnus vrais par l’Assemblée, celle-ci, après discussion et délibération, a unanimement
pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide de transférer le siège de la société à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, la première phrase de l’article 2 des statuts est modifié et aura désormais
la teneur suivante:
« Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.».
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée décide de prendre acte de la démission de l’administrateur-délégué Nico Rollinger et du commissaire aux
comptes Monsieur Jorge Guedes avec effet au 04 juillet 2014.
Décharge pleine et entière leur est donnée pour l’exécution de leurs mandats.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée décide de nommer avec effet au 04 juillet 2014 comme nouvel administrateur pour une durée de six (6)
ans Monsieur Philippe Wasila, né le 15 février 1967 à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-2212 Luxembourg,
6, Place de Nancy.
L’Assemblée décide de nommer avec effet au 04 juillet 2014, comme nouvel nouveau commissaire aux comptes pour
une durée de six (6) ans Monsieur Stephan Allart, né le 13 février 1981 à Uccle (B), demeurant professionnellement à
L-1931, Luxembourg, 45, avenue de la Liberté.
Plus rien n'étant à l’ordre du jour, et plus aucun actionnaire ne désirant prendre la parole, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Helmsange, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par nom, prénom
usuel, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte, aucun actionnaire n’ayant exprimé
le souhait de le signer.
Signé: Rollinger, Zhang, Wasila, Jean-Paul Meyers.
Enregistré à Redange/Attert, le 09 juillet 2014. Relation: RED/2014/1481. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Kirsch.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée sur papier libre, aux fins d’enregistrement auprès du R.C.S.L. et de la
publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Rambrouch, le 11 juillet 2014.
Jean-Paul MEYERS.
Référence de publication: 2014106131/61.
(140126766) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2014.
Chapes Bâtiments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4959 Bascharage, 54, op Zaemer.
R.C.S. Luxembourg B 188.784.
STATUTS
L'an deux mille quatorze, le vingt-sept juin
Par-devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg
A comparu:
Monsieur Philippe LOPES, technicien en bâtiment, demeurant à L-7445 Lintgen, 17, rue de l'Ecole.
126137
L
U X E M B O U R G
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité
limitée qu'il déclare constituer:
Titre I
er
. Dénomination - Siège social - Objet - Durée - Capital social
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront
le devenir par la suite une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois qui sera régie par les lois y relatives
ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet la confection de chapes et toutes les activités s'y rapportant.
En outre, la société pourra exercer toute autre activité commerciale à moins qu'elle ne soit spécialement réglementée.
D'une façon générale, elle pourra faire toutes les opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se
rattachant directement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou développer la réalisation.
Art. 3. La société prend la dénomination de «Chapes Bâtiments S.à r.l.».
Art. 4. Le siège social est établi à Bascharage.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés. La
société peut ouvrir des agences ou des succursales dans toutes les autres localités du pays et à l'étranger.
Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète des circonstances anormales. Une
telle décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la Société. La déclaration de transfert de siège sera faite et portée à
la connaissance des tiers par l'organe de la Société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.
Art. 5. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de 15.000,-EUR (quinze mille euros), représenté par 100 (cent) parts sociales
d'une valeur nominale de 150,-EUR (cent cinquante euros) chacune.
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-
naires.
Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle du nombre des parts existantes dans l'actif
social et dans les bénéfices.
Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées à des non-associés
qu'avec l'agrément donné en assemblée des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Titre II. Administration - Assemblée Générale
Art. 9. La société est administrée et gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, salariés ou gratuits, nommés
par l'assemblée des associés, qui fixe leurs pouvoirs. Ils peuvent à tout moment être révoqués par l'assemblée des associés.
A moins que l'associé unique ou les associés n'en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus
pour agir au nom de la société en toutes circonstances.
En tant que simple mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction aucune
obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; ils ne seront
responsables que de l'exécution de leur mandat.
Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts lui appartenant.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente; chaque associé peut se
faire représenter valablement aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles aient été adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux présents statuts doivent être prises à la majorité des
associés représentant les trois quarts du capital social.
Titre III. Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 12. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 13. Chaque année, à la clôture de l'exercice, les comptes de la société sont arrêtés et la gérance dresse les comptes
sociaux, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Art. 14. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.
Art. 15. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugées
nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.
Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition des associés.
126138
L
U X E M B O U R G
Titre IV. Dissolution - Liquidation
Art. 16. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé ou de l'associé
unique.
Art. 17. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer
des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilans et inventaires de la société.
Art. 18. En cas de dissolution de la société, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés, qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Disposition générale
Art. 19. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions légales en vigueur régissant les sociétés à responsabilité limitée.
<i>Dispositions transitoirei>
Par exception le premier exercice commencera le jour de la constitution et finira le trente et un décembre deux mille
quatorze
<i>Souscription et libérationi>
Les parts sociales ont toutes été souscrites comme suit:
Monsieur Philippe LOPES, prénommé, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de
douze mille cinq cents Euros se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au
notaire instrumentant qui le constate expressément.
<i>Evaluation des Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s'élèvent approximativement à la somme de neuf cent cinquante
Euros (950.-EUR).
<i>Décisions des associés:i>
Et ensuite le comparant devenu l'associé unique, et représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions
suivantes:
1. L'adresse de la Société est fixée au 54, op Zaemer, L-4959 Bascharage.
2. Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
Monsieur Philippe LOPES, prénommé, né le 13 juin 1985, à Esch-sur-Alzette, demeurant à L-7445 Lintgen, 17, rue de
l'Ecole.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte au comparant, connu du notaire par nom, prénom, état civil et demeure, il a signé avec
le Notaire le présent acte.
Signé: Ph. LOPES, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 1
er
juillet 2014. Relation: LAC/2014/30294. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Carole FRISING.
POUR COPIE CONFORME, délivrée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.
Luxembourg, le 21 juillet 2014.
Référence de publication: 2014106429/103.
(140127995) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.
Distribution Automobiles Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1740 Luxembourg, 20, rue d'Hollerich.
R.C.S. Luxembourg B 146.553.
DISSOLUTION
L'an deux mille quatorze, le quatre juillet.
Pardevant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
A comparu:
126139
L
U X E M B O U R G
- La société KASHYK S.A., établie et ayant son siège social à L-1740 Luxembourg, 20, rue d'Hollerich, inscrite au
registre du commerce et des sociétés sous le numéro B125.122, ici représentée par Monsieur Riccardo Incani, employé,
résidant professionnellement à L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste, en vertu d'une procuration donnée sous seing
privé en date du 1
er
juillet 2014,
Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la comparante et le notaire
instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
La partie comparante, représentée comme il est dit ci-dessus, expose ce qui suit:
1) Elle est propriétaire de la totalité des parts de la société "DISTRIBUTION AUTOMOBILES LUXEMBOURG S.àr.l."
établie et ayant son siège social à L-1740 Luxembourg, 20, rue d'Hollerich, inscrite au Registre de Commerce de Lu-
xembourg sous le numéro B 146.553, constituée suivant acte du notaire Paul BETTINGEN de Niederanven du 26 mai
2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 1278 du 2 juillet 2009, non modifiée depuis
et dont le capital social est fixé à cinquante mille euros (EUR 50.000,-), représenté par cinq cents (500) parts d'une valeur
nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, entièrement libérées.
2) L'activité de la Société a cessé.
3) Siégeant en assemblée générale extraordinaire modificative des statuts de la Société, elle prononce la dissolution
anticipée de la Société avec effet immédiat.
4) Elle se désigne comme liquidateur de la Société, et en cette qualité, requiert le notaire d'acter que tout le passif de
la Société est réglé tandis que le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment approvisionné et qu'enfin,
par rapport à d'éventuels passifs de la Société actuellement inconnus et donc non encore payés, elle assume irrévoca-
blement l’obligation de les payer de sorte que tout le passif de la Société est réglé.
5) L'actif restant est attribué à l’associée unique.
6) La liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.
7) Décharge pleine et entière est donnée aux gérants de la Société.
8) Les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq (5) ans à l’ancien siège social.
9) Déclaration que, conformément à la loi du 12 novembre 2004, l’associée actuelle est le bénéficiaire économique de
l’opération.
Pour les publications et dépôts à faire, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, il a signé avec Nous, notaire, le
présent acte.
Signé: INCANI, ARRENSDORFF.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 4 juillet 2014. Relation: LAC / 2014 / 31182. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.
Luxembourg, le 21 juillet 2014.
Référence de publication: 2014106526/47.
(140127471) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.
ACE Fashion S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3898 Foetz, 1, rue du Brill.
R.C.S. Luxembourg B 50.182.
L'an deux mille quatorze, le neuf mai.
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est réunie
l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «ACE FASHION S.A.», ayant son siège
social à L-3898 Foetz, 1, rue du Brill, inscrite sous le numéro B 50.182 auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
de et à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Joseph ELVINGER, alors notaire de résidence à Dudelange,
en date du 24 janvier 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2924 du 3 juin 1995.
Les statuts de ladite société ont été modifiés pour la dernière fois par un acte du notaire instrumentaire en date du 4
octobre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2924 du 20 novembre 2013.
L'assemblée est présidée par Madame Francine MONIOT, employée privée, demeurant professionnellement à L-1258
Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Gianpiero SADDI, employé privé, demeurant professionnellement à L-1750
Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.
126140
L
U X E M B O U R G
L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Francine MONIOT, prénommée. Le bureau ainsi constitué, Madame
le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence signée «ne varietur» par les actionnaires présents, les
mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste
de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de
l’enregistrement.
II. Que l’intégralité du capital social étant présent ou représenté à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant, par
ailleurs, avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
III. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jouri>
1) Modification de la date de l’assemblée générale annuelle;
2) Modification subséquente de l’article 15, premier alinéa, des statuts de la société;
3) Divers.
L’assemblée a approuvé l’exposé de Madame le Président et, après avoir reconnu qu’elle était régulièrement constituée
et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix, et sans abstentions, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide avec effet immédiat et s’appliquant déjà à l’année 2014 en cours, de modifier la date de
l’assemblée générale annuelle au 1
er
lundi du mois de juin.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l’article 15, premier alinéa, des statuts de la société aura la teneur suivante:
« Art. 15. premier alinéa. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué
dans la convocation, le premier lundi du mois de juin à 10.00 heures.»
<i>Disposition transitoirei>
L’assemblée générale annuelle de l’année 2014 statuant sur l’exercice 2013, aura lieu le premier lundi du mois de juin.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges qui incombent à la société en raison du présent acte sont évalués ap-
proximativement à la somme de mille deux cents euros (1.200.- EUR).
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures,
lesdits comparants ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: F. Moniot, G. Saddi et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 12 mai 2014. Relation: LAC/2014/21843. Reçu soixante-quinze euros Eur
75.-
<i>Le Receveuri>
(signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d’inscription au Registre de
Commerce.
Luxembourg, le 21 juillet 2014.
Référence de publication: 2014106320/59.
(140127290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.
ADVICE.INC S.à r.l. SPF, Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 171.886.
L'an deux mille quatorze, le huit juillet.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
S'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée «ADVICE.INC S.à r.l. SPF», ayant
son siège social à L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant,
126141
L
U X E M B O U R G
en date du 2 octobre 2012, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 2683 du 2 novembre
2012.
L'assemblée se compose de son seul et unique associé à savoir:
MONTEREY BUSINESS CENTER S.A., RCS Luxembourg B 78.967 ayant son siège social à L-1140 Luxembourg, 113,
route d'Arlon,
ici représentée par son administrateur unique, Monsieur Jean Naveaux, demeurant professionnellement à L-1140
Luxembourg, 113, route d'Arlon.
Ceci exposé, le comparant prémentionné, ès-qualité qu'il agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi
qu'il suit les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé décide d'abandonner le statut de société de gestion de patrimoine familial et de modifier l'article deux des
statuts relatif à l'objet social comme suit:
«La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations
sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développe-
ment de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un
portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.»
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de ce qui précède, l'Associé unique décide de modifier l'article 1
er
des statuts comme suit:
«Il existe une société à responsabilité limitée qui est régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après, la Société),
et en particulier la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après, la Loi), ainsi
que par les présents statuts (ci-après, les Statuts).
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé unique décide également de modifier la dénomination de la Société en ADVICE.INC S.à r.l. et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts comme suit:
«La Société a comme dénomination ADVICE.INC S.à r.l.»
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier l'article 21 des statuts comme suit:
«Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août
1915 et aux lois modificatives.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire des parties comparantes a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: J. NAVEAUX et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 14 juillet 2014. Relation: LAC/2014/32892. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 21 juillet 2014.
Référence de publication: 2014106325/54.
(140127658) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.
FFV SCSp, Société en Commandite spéciale.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 188.770.
STATUTS
<i>Extraiti>
I. Dénomination et durée. La société en commandite spéciale ayant pour dénomination «FFV S.C.Sp», a été constituée
par acte sous seing privé signé en date du 27 juin 2014 pour une durée illimitée (ci-après la «Société»).
126142
L
U X E M B O U R G
II. Siège social. le siège social de la Société est établi au 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg.
III. Objet social. Il résulte du contrat social que l'objet social de la Société est le suivant:
«The purpose of the Partnership is to hold an Investment in the Investment Holding.
The Partnership may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to companies
or other enterprises in which the Partnership has an interest or which form part of the group of companies to which the
Partnership belongs (including Partners or affiliated entities) or any other companies. The Partnership may further pledge,
transfer, encumber or otherwise create security over all or over some of its assets.
The Partnership may borrow in any form by way of private placements. It may issue notes, bonds and debentures and
any kind of debt, whether convertible or not, and/or equity securities.»
Traduction française de l'objet social, la version anglaise prévalant:
«L'objet du de la Société est de détenir un Investissement dans la Holding d'Investissement.
La Société peut accorder tout concours (par voie de prêts, avances, garanties, sûretés ou autres) aux sociétés ou
entités dans lesquelles elle détient une participation ou faisant partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société
(y compris ses actionnaires ou entités affiliées) ou à toute autre société. La Société peut en outre nantir, céder, grever
de charges ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur tout ou partie de ses actifs.
La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, par voie de placements privés. Elle peut procéder à
l'émission d'obligations et d'autres titres représentatifs de créances, convertibles ou non, et/ou titres de participation.»
IV. Désignation des associés solidaires. L'associé commandité de la Société est FFV GP S.à r.l., une société à respon-
sabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché
de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
187761.
V. Désignation des gérants. FFV GP S.à r.l., précitée, a été nommée en tant que associé commandité gérant pour une
durée illimitée.
VI. Pouvoir de signature du gérant. Envers les tiers, la Société est valablement engagée par la seule signature de son
associé commandité gérant.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 21 juillet 2014.
Référence de publication: 2014106642/39.
(140127587) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.
G.D.E. Finances S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8041 Strassen, 65, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 185.439.
L'an deux mille quatorze, le quinze juillet.
Par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit
une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée "G.D.E. FINANCES S. à R.L.",
ayant son siège social à L-3327 Crauthem, 8, Zone Industrielle Am Bruch, R.C.S. Luxembourg section B numéro 185.439,
constituée suivant acte reçu le 13 mars 2014, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro
1319 du 22 mai 2014.
L'assemblée est présidée par Madame Rachel Uhl, Juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.
La présidente désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Susana MOUTINHO,
employée privée, demeurant professionnellement à Strassen.
La présidente prie le notaire d'acter que:
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre de parts sociales qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste
de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront
ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.
II.- Il ressort de la liste de présence que les parts, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la
présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés
à l'ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.
III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Transfert du siège social à l'adresse suivante: L-8041 Strassen, 65, Rue des Romains.
126143
L
U X E M B O U R G
2.- Modification afférente de l'article 5 des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les associés décident ce qui suit à l'unanimité:
<i>Première résolution:i>
L’assemblée décide de transférer le siège social de la société à l'adresse suivante: 65, Rue des Romains, L-8041 Strassen.
<i>Deuxième résolution:i>
Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 5
des statuts pour lui donner la teneur suivante:
"Le siège social est établi à Strassen."
<i>Frais:i>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille deux cents Euros.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparantes, elles ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: R. UHL, S. MOUTINHO, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils le 17 juillet 2014. Relation: LAC/2014/33606. Reçu soixante-quinze euros (EUR
75,-)
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
Référence de publication: 2014106657/45.
(140127951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.
Eneris International S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-5753 Frisange, 43, Parc Lésigny.
R.C.S. Luxembourg B 159.919.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014106553/9.
(140127242) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.
Emery S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 162.752.
EXTRAIT
En date du 17 juillet 2014, l'actionnaire unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- La démission de En Lee, en tant que gérant de classe B de la Société, est acceptée avec effet au 21 juillet 2014;
- Virginia Strelen, avec adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est élue nouveau
gérant de classe B de la Société avec effet au 21 juillet 2014 et ce, pour une durée indéterminée.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2014106548/14.
(140127283) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.
Eneris Poland S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5753 Frisange, 43, Parc Lésigny.
R.C.S. Luxembourg B 75.118.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014106554/9.
(140127247) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
126144
ACE Fashion S.A.
ADVICE.INC S.à r.l. SPF
Bärlu S.à r.l.
Chapes Bâtiments S.à r.l.
Chiapparo G.m.b.h.
Distribution Automobiles Luxembourg S.à r.l.
Eastern Bulk
ECE Real Estate Partners S.à r.l.
Ech Lux 2 (Heilbronn) S.à r.l.
ECommerce Holding II S.à r.l.
EDEL Capital S.A.
Emery S.à r.l.
Eneris International S.A.
Eneris Poland S.A.
Entreprise de Transports Nello Bei-Quaglia
Enuma Holding S.A.
EOF Soparfi A S.à r.l.
EOF Soparfi B S.à r.l.
Epicerie Sylvie S.à r.l.
EPI Highgate S.à.r.l.
EPISO 3 Luxembourg Holding S.à r.l.
Erice S.A.
Ernst August Carree S.à r.l.
Euroamerican Finance S.A.
Family Affair S.à r.l.
Farta V S.A.
FDM Investment Corporation Soparfi
FEC Lux S.à r.l.
Fegon International S.A.
Fertitrust S.A.
FFV SCSp
FIB-Services Intellectual S.A.
Finsevi S.A.
Fissler A.G.
FL Finance S.A.
Fontgrande S.A.
Forever S.A., SPF
FPI LUX S.A., SPF
Fusion Poland Holdco S.à r.l.
GASTRONOMICA LUXEMBOURG S.à r.l.
Gazania Capital S.à r.l.
G.D.E. Finances S.à r.l.
G.D.E. Finances S.à r.l.
Geffco Holding S.A.
Genesta Nordic Baltic Real Estate S.à r.l., SICAR
GIA Finance S.A.
GJL Management (Lux) S.à r.l.
G-Lab S.A.
GM Topco S.à r.l.
Goodman Princeton Holdings (Lux) S.à r.l.
Goodyear
Greiwels S.à r.l.
GTCR Gridlock Holdings (Luxembourg) S.à r.l.
Hosta
Ice Midco Limited S.A.
Inesia S.A.
IRACO, Comptoir d'Importations, Représentations et Agences
Sarasino Soparfi S.A.
Société Européenne d'Expansion Immobilière S.A.
Solanis S.A.
Weldiflex