This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2575
23 septembre 2014
SOMMAIRE
Algos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123571
Azurline S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123565
Bahian S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123555
Base-Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123556
Baumert,s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123554
BBA sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123578
BIL Prime Advanced . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123566
Bistro Dream S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123566
BJT S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123565
BRC S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123555
Bull's-Eye Property Lux SA . . . . . . . . . . . . .
123555
CB Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123563
Cebtimo SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123563
ChemCore S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123556
Clairefontaine Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . .
123561
Coreval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123561
Creos Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
123562
Criali Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123561
Del Monte Luxembourg SARL . . . . . . . . . .
123562
Digital Services Holding XXIII S.à r.l. . . . .
123579
Dominium Topco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
123589
European Opticians 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
123560
First Geneva SICAV-FIS S.A. . . . . . . . . . . . .
123562
Gohu S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123564
Green Europe Lux s.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
123564
Hess (Luxembourg) Exploration and Pro-
duction Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
123565
La Boqueria S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123567
LCB Prop Co. C S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
123554
LF Hotels Acquisition S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
123597
LPFE Soparfi A S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123599
Main Tower Development S.à r.l. . . . . . . . .
123557
Manuel Machado S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
123557
Mathey Mazout S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123554
MCL Prop Co. A S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
123557
Meneghetti Groupe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
123563
MGE Remscheid SiteCo S.à r.l. . . . . . . . . . .
123556
Mobile Challenger Intermediate Group
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123557
Mohican S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123566
Mosqueteiros S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123558
MSEOF Pascal Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
123563
Mudra Capital S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123558
Murus Location S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123558
NF Lux Buildings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123554
Norama Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123554
NTT Cable Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
123566
O.E.M. SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123578
Osborne & Moore S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
123564
OZ Carbon Trading (Lux) S. à r.l. . . . . . . .
123578
Oz Holding S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123564
Partinvest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123565
Perunna S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123564
PTL Holdings Luxembourg Sàrl . . . . . . . . .
123568
Radar S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123559
Regie.lu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123558
Rhino HoldCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123559
Welcome S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123560
WMC Securitisation S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
123560
WP Roaming I S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123559
123553
L
U X E M B O U R G
LCB Prop Co. C S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5326 Contern, 17, rue Edmond Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 158.404.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014103304/9.
(140122322) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2014.
Mathey Mazout S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1141 Luxembourg, 103, rue des Artisans.
R.C.S. Luxembourg B 170.977.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014103331/9.
(140122220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2014.
NF Lux Buildings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 146.466.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour NF LUX BUILDINGS S.A.i>
Référence de publication: 2014103393/10.
(140122765) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2014.
Norama Fund, Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 171.064.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 06.05.2014.
Paul DECKER
<i>Le Notairei>
Référence de publication: 2014103385/12.
(140121599) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2014.
Baumert,s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1243 Luxembourg, 5, rue Félix de Blochausen.
R.C.S. Luxembourg B 62.583.
Le bilan au 31.12.2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juillet 2014.
Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L- 1013 Luxembourg
Référence de publication: 2014105547/14.
(140126564) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2014.
123554
L
U X E M B O U R G
Bahian S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7243 Bereldange, 68, rue du X Octobre.
R.C.S. Luxembourg B 179.475.
<i>Extrait de la réunion des associés en date du 18 juin 2014 à Luxembourgi>
Suivant convention de cession du 18 juin 2014, Monsieur Danoush Rassekh, avec adresse à L-7243 Bereldange cède
58.195 (cinquante-huit mille cent quatre-vingt-quinze) parts sociales de la société Bahian Sàrl, avec siège social à L-7243
Bereldange, 68, rue du X Octobre
à Mademoiselle Sophia HAMILTON, avec adresse à 2070 Tunis, La Marsa, 7, rue Ali Bach Hamba.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Fiduplan S.A.
Référence de publication: 2014105535/15.
(140126721) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2014.
BRC S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 748.885.344,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 99.842.
<i>Extrait des résolutions du conseil de gérancei>
En date du 18 juillet 2014, le conseil de gérance a décidé de transférer le siège social de la société du 1, Rue Schiller,
L-2519 Luxembourg, au 3, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juillet 2014.
Carsten SÖNS
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2014105566/15.
(140126962) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2014.
Bull's-Eye Property Lux SA, Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12-14, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 138.135.
<i>Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue de manière extraordinaire le 17 juin 2014i>
Les mandats des administrateurs et du Commissaire aux comptes étant arrivés à échéance, l'Assemblée décide de les
renouveler:
- Sont élus aux fonctions d'administrateurs de la société pour une durée de 3 ans, jusqu'à l'Assemblée générale statuant
sur les comptes clos au 31 décembre 2016:
<i>Administrateur A - Présidenti>
* Monsieur Marnix Galle, né le 22 juillet 1963 à Watermaal-Bosvoorde (Belgique) résidant B-8300 Knokke (B) As-
tridlaan, 14.
<i>Administrateurs Bi>
* Monsieur Fernand Pesch, né le 22 février 1938 à Luxembourg résidant à L-8232 Mamer, rue de Holzem, 28;
* Monsieur Wolfgang Baertz, né le 19 juin 1940 à Düsseldorf (Allemagne) résidant à L-8123 Bridel, Bei den 5 Buchen,
4.
- Est élue aux fonctions de Commissaire aux comptes de la société pour une durée de 3 ans, jusqu'à l'Assemblée
générale statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2016:
* La société Lut Laget Tax Audit & Accountancy, anciennement Van Geet Derick, Experts-Comptables Sàrl, avec siège
social à L-1258 Luxembourg, 6, Rue Jean-Pierre Brasseur, enregistrée sous le numéro R.C.S. Luxembourg N°53.981.
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2014105542/24.
(140126433) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2014.
123555
L
U X E M B O U R G
Base-Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 102.457.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue le 16 juillet 2014, que la
liquidation de la société décidée en date du 28 mars 2014 a été clôturée; et que la société BASE-INVEST S.A., a définiti-
vement cessé d'exister. Les livres et documents sociaux sont déposés et conservés pour une période de cinq ans au 42,
Rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg.
Luxembourg, le 18 juillet 2014.
<i>Pour: BASE-INVEST S.A.
i>Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Référence de publication: 2014105545/17.
(140126335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2014.
MGE Remscheid SiteCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1857 Luxembourg, 5, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 134.284.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associée unique en date du 13 juin 2014i>
1. Monsieur Gary BOND a démissionné de ses mandats de gérant et de président du conseil de gérance.
2. Monsieur Richard Michael LEE, administrateur de sociétés, né à Wallsend upon Tyne (Royaume-Uni), le 14 janvier
1965, demeurant professionnellement à c/o McArthurGlen UK Limited, Nations House, 103 Wigmore Street, W1U 1WH
Londres (Royaume-Uni), a été nommé comme gérant pour une durée indéterminée.
<i>Extrait des résolutions prises par le conseil de gérance en date du 16 juin 2014i>
Monsieur Richard Michael LEE a été nommé comme président du conseil de gérance pour une durée indéterminée.
Luxembourg, le 21 juillet 2014.
Pour extrait sincères et conformes
<i>Pour MGE Remscheid SiteCo S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.
Référence de publication: 2014106901/18.
(140127331) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.
ChemCore S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 57.934.
Lors de l'assemblée générale annuelle tenue en date du 4 juillet 2014, les actionnaires ont pris les décisions suivantes:
1. renouvellement du mandat des administrateurs suivants:
- Franck Doineau, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- Noëlla Antoine, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- Ruth Sandelowsky, avec adresse au 9, Laubehof, Metallstrasse, 6300 Zug, Suisse
pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice
social se clôturant au 31 décembre 2014 et qui se tiendra en 2015.
2. renouvellement du mandat de commissaire aux comptes de Alter Domus Luxembourg S.à r.l., avec siège social au
5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle
qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2014 et qui se tiendra en 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juillet 2014.
Référence de publication: 2014106430/19.
(140127453) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.
123556
L
U X E M B O U R G
MCL Prop Co. A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5326 Contern, 17, rue Edmond Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 174.919.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014106896/9.
(140127307) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.
Main Tower Development S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 107.637.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juillet 2014.
Référence de publication: 2014106892/10.
(140127800) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.
Manuel Machado S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7349 Heisdorf, 19, rue Henri de Stein.
R.C.S. Luxembourg B 58.524.
Le bilan au 31.12.2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juillet 2014.
Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L-1013 Luxembourg
Référence de publication: 2014106895/14.
(140127400) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.
Mobile Challenger Intermediate Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 159.933.
Lors de l'assemblée générale annuelle tenue en date du 19 juin 2014, les actionnaires ont pris les décisions suivantes:
1. Renouvellement du mandat des administrateurs suivants:
- Emanuela Brero, avec adresse professionnelle au 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
- Stefan Oostvogels, avec adresse au 1, rue Spierzelt, L-8063 Bertrange
- Manuel Mouget, avec adresse professionnelle au 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
- Daniel Pindur, avec adresse au 24, WestendDuo, Bockenheimer Landstrasse, 60323 Frankfurt-am-Main, Allemagne
- Lorne Somerville, avec adresse au 111, Strand, WC2R 0AG Londres, Royaume-Uni
pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice
social se clôturant au 31 décembre 2014 et qui se tiendra en 2015;
2. Renouvellement du mandat de réviseur d'entreprises agréé de ERNST & YOUNG, avec siège social au 7, rue Gabriel
Lippmann, L-5365 Munsbach, pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur
les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2014 et qui se tiendra en 2015;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juillet 2014.
Référence de publication: 2014106888/21.
(140127998) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.
123557
L
U X E M B O U R G
Mosqueteiros S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.
R.C.S. Luxembourg B 149.075.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014106914/10.
(140126732) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.
Murus Location S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7420 Cruchten, 10, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 76.148.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>L'administrateuri>
Référence de publication: 2014106919/11.
(140127830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.
Mudra Capital S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 144.662.
Conformément aux dispositions de l'article 64 (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
les Administrateurs élisent en leur sein une Présidente en la personne de Madame Anne-Marie GREGIS. Cette dernière
assumera cette fonction pendant la durée de son mandat qui viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire
de l'an 2020.
Luxembourg, le 16 juin 2014.
MUDRA CAPITAL SA
Référence de publication: 2014106917/13.
(140127575) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.
Regie.lu, Société Anonyme.
Siège social: L-2339 Luxembourg, 2, rue Christophe Plantin.
R.C.S. Luxembourg B 65.930.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 9 juillet 2014i>
L'assemblée générale prend acte de la cooptation par le Conseil d'administration du 5 décembre 2013 de Monsieur
Pascal Marchesin comme nouveau membre du conseil d'administration. Suite à ce constat, l'assemblée générale ratifie
cette cooptation.
Les mandats des membres du conseil d'administration arrivent à échéance.
L'assemblée générale décide de renouveler les mandats des MM. Paul PECKELS, Robert HEVER et Pascal MARCHESIN,
demeurant tous les trois professionnellement à 2 rue Christophe Plantin, L-2339 Luxembourg au conseil d'administration
jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2020.
Le mandat du commissaire aux comptes vient à échéance. L'assemblée générale décide de renouveler le mandat de
M. Georges Heirendt, demeurant professionnellement à 2 rue Christophe Plantin L-2339 Luxembourg jusqu'à l'assemblée
générale annuelle qui se tiendra en 2020.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 23 juillet 2014.
Référence de publication: 2014107893/20.
(140129294) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2014.
123558
L
U X E M B O U R G
Rhino HoldCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 168.290.
Les comptes annuels de la société Rhino Holdco S.à r.l. au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014107875/10.
(140128236) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2014.
WP Roaming I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 3.513.800,00.
Siège social: L-5326 Contern, 15, rue Edmond Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 108.604.
EXTRAIT
Il résulte de la résolution de l'associé unique de la Société en date du 27 Juin 2014 que les mandats en tant que membres
du conseil de gérance de Mrs Laura Binion, Mr Morten Brogger, Mr David Hitchcock et Mr Nelson Murphy ont été
renouvelés, leurs mandats se terminant lors de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de la Société pour
l'exercice social se terminant au 31 Décembre 2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 Juillet 2014.
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2014108062/17.
(140128835) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2014.
Radar S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1143 Luxembourg, 24, rue Astrid.
R.C.S. Luxembourg B 165.197.
<i>Extrait de la décision collective du 16 juillet 2014i>
<i>Première résolutioni>
Les associés prennent acte des cessions de parts du 16 juillet 2014. Suite à ces cessions, la nouvelle répartition du
capital social est la suivante:
- Benjamin ANDREWS, réalisateur de films, demeurant 65, rue de Steinsel à L-7254 Bereldange, propriétaire de 250
parts.
Frédéric NEUEN, réalisateur de films, demeurant 23, rue Emile Metz à L-2149 Luxembourg, propriétaire de 250 parts.
- Tim LECOMTE, administrateur de sociétés, demeurant 32, rue Mathias Koener à L-4174 Esch-sur-Alzette, proprié-
taire de 250 parts.
- SILVER ROCKET, société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social au 24, rue Astrid à L-1143
Luxembourg, immatriculée au RCS sous le numéro B 162883, propriétaire de 250 parts.
<i>Deuxième résolutioni>
Les associés acceptent la démission de Monsieur Fred BAUS de son poste de gérant administratif de la société.
<i>Troisième résolutioni>
Les associés décident de transférer, avec effet immédiat, le siège social de la société RADAR S.à r.l. de 8, rue Letellier,
L-1932 Luxembourg à 24 rue Astrid, L-1143 Luxembourg.
Pour extrait conforme
Fiduciaire Pietschette, Meisch & Associés S.A.
Signature
Référence de publication: 2014107883/27.
(140128495) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2014.
123559
L
U X E M B O U R G
Welcome S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4051 Esch-sur-Alzette, 103, rue du Canal.
R.C.S. Luxembourg B 50.268.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Fiduciaire WBM
<i>Experts comptables et fiscaux
i>Signature
Référence de publication: 2014108059/13.
(140129044) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2014.
European Opticians 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 250.000,00.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 115.161.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
La clôture de la liquidation de la Société a été décidée lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue sous seing
privé le 17 juillet 2014. La Société a donc cessé d'exister à partir de ce jour, le 17 juillet 2014.
Les livres et les documents sociaux de la Société dissoute seront conservés pendant le ai légal de 5 ans au 2, avenue
Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 juillet 2014.
Halsey S.àr.l.
Signature
<i>Liquidateuri>
Référence de publication: 2014109359/18.
(140130441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2014.
WMC Securitisation S.A., Société Anonyme de Titrisation.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 186.290.
EXTRAIT
Il résulte d'une décision prise par l'actionnaire unique de la Société en date du 22 juillet 2014 que:
- Les démissions de Messieurs Philip Godley et James Saout sont acceptés, avec effet au 22 juillet 2014;
- Monsieur Rolf Caspers, né le 12 mars 1968 à Trier, Allemagne, demeurant professionnellement au 51 avenue John
F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, et Monsieur John Wiseman, né le 22 août 1971 à Jersey, demeurant professionnellement
au 13 Castle Street, JE4 5UT, St Helier, Jersey, sont élus administrateurs de la Société en remplacement de Messieurs
Philip Godley et James Saout démissionnaires, avec effet au 22 juillet 2014, jusqu'à l'assemblée générale de la Société qui
sera tenue en 2015.
Le conseil d'administration se compose dorénavant comme suit:
- Rolf Caspers
- Alexandra Fantuz
- Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 juillet 2014.
Pour extrait sincère et conforme
Sanne Group (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2014108061/23.
(140129097) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2014.
123560
L
U X E M B O U R G
Coreval, Société Anonyme.
Siège social: L-8030 Strassen, 145, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 32.573.
<i>Extrait du Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle tenue le 24 juin 2014 à 11 heures au siègei>
<i>social de la sociétéi>
<i>Septième résolution:i>
L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat de Réviseur d'Entreprises indépendant de la société ERNST &
YOUNG S.A., qui expire à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'année 2015 statuant sur les comptes de l'exer-
cice clos au 31 décembre 2014.
Référence de publication: 2014109275/13.
(140131395) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2014.
Clairefontaine Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 313.000,00.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 1, côte d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 69.350.
<i>Extrait des décisions du Conseil de gérance tenu en date du 21 juillet 2014i>
Le Conseil de gérance a décidé de transférer le siège social de la société au 1, cote d'Eich, L-1450 Luxembourg avec
effet au 15 Juillet 2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Christophe Cahuzac
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2014109264/15.
(140130696) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2014.
Criali Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 110.028.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 9 juillet 2014i>
Il résulte du procès-verbal que:
L'assemblée décide d'approuver le transfert du siège social de la Société du 45-47, route d'Arlon, 1140 Luxembourg
au 128, Boulevard de la Pétrusse, 2330 Luxembourg avec effet immédiat.
Suite à la réception par la Société d'un courrier daté du 3 juillet 2014 et dûment produit à la présente assemblée,
l'assemblée prend acte de la démission de Madame Nadia Digiuni Sprenger de son mandat d'administrateur de la Société,
avec effet à la date de la présente assemblée.
L'Assemblée de nommer avec effet immédiat et jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société
qui se tiendra en 2017 les personnes suivantes en tant que nouveaux administrateurs de la Société:
- Mr. Stéphane Biver, ayant pour adresse professionnelle le 128 Boulevard de la Pétrusse, 2330 Luxembourg; et
- Mr. Pierluigi Ciccone, ayant pour adresse professionnelle, Palazzo Mantegazza, Riva Paradiso 2, 6900 Lugano Paradiso,
Suisse.
L'assemblée décide d'approuver de nommer en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire et jusqu'à
l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société qui se tiendra en 2017 l'entité suivante en tant que nouveau
commissaire aux comptes de la Société:
- Data Graphic S.A., ayant son siège social au 128, Boulevard de la Pétrusse, 2330 Luxembourg, inscrite au registre du
Commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 42.166.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
CRIALI INVESTMENT S.A.
Référence de publication: 2014109284/26.
(140131732) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2014.
123561
L
U X E M B O U R G
Creos Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1248 Luxembourg, 59-61, rue de Bouillon.
R.C.S. Luxembourg B 4.513.
<i>Assemblée générale ordinaire de Creos Luxembourg du 13 mai 2014i>
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de Creos Luxembourg tenue le 13 mai 2014 à Strassen
que l'assemblée générale a pris note de la nomination comme administrateurs et représentants du personnel de:
Monsieur André GILBERTZ, né le 24 juillet 1950 à Pétange et ayant son adresse professionnelle au 2, rue Thomas
Edison à L-1445 Strassen;
Monsieur Claude REDER, né le 16 janvier 1978 à Pétange et ayant son adresse professionnelle au 2, route de Bergem
à L-3818 Schifflange.
La durée des mandats est de six ans, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2020 appelée à statuer sur les
comptes de l'exercice 2019.
Strassen, le 21 juillet 2014.
Référence de publication: 2014109283/17.
(140131746) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2014.
First Geneva SICAV-FIS S.A., Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement
Spécialisé.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 170.906.
<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration par voie circulaire en date du 7 Mai 2014i>
Il est décidé:
- de prendre note de la démission de Monsieur André SCHMIT en tant qu'Administrateur.
- de coopter Monsieur Aurélien BARON, résidant professionnellement au 11 rue Aldringen, L-2960 Luxembourg,
comme Administrateur en remplacement de Monsieur André SCHMIT, démissionnaire.
- que Monsieur Aurélien BARON termine le mandat de son prédécesseur.
- de proposer à la prochaine Assemblée Générale Statutaire de ratifier la cooptation de Monsieur Aurélien BARON.
Certifié conforme et sincère
<i>Pour FIRST GENEVA SICAV-FIS S.A.
i>KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Référence de publication: 2014109382/18.
(140131136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2014.
Del Monte Luxembourg SARL, Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 19.673.668,00.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 168.516.
EXTRAIT
Le conseil de gérance de la Société a décidé, en date du 18 juillet 2014, de transférer le siège social de la Société au
16A, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, avec effet au 18 juillet 2014.
L'assemblée générale des associés de la Société a décidé en date du 18 juillet 2014 d'accepter la démission de Monsieur
Pietro Longo de son poste de gérant de catégorie B de la Société.
L'assemblée générale des associés de la Société a également décidé en date du 18 juillet 2014 de nommer Penta
Consulting S.à r.l., avec siège social au 21, boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, et immatriculé e au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 92846, en
tant que nouveau gérant de catégorie B en remplacement de Monsieur Pietro Longo, pour une période indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Del Monte Fresh Produce SARLi>
Référence de publication: 2014109293/19.
(140131717) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2014.
123562
L
U X E M B O U R G
Meneghetti Groupe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 100.126.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014103353/9.
(140122526) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2014.
Cebtimo SA, Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 51.703.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juillet 2014.
Référence de publication: 2014109253/10.
(140131520) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2014.
MSEOF Pascal Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 108.947.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Stefan KOCH.
Référence de publication: 2014103372/10.
(140122661) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2014.
CB Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 138.887.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
Il résulte d'un acte de clôture de liquidation reçu par le notaire Martine SCHAEFFER, de résidence à Luxembourg, en
date du 11 juillet 2014, enregistré à Luxembourg A.C., le 21 juillet 2014, LAC/2014/34120, aux droits de soixante-quinze
euros (75.- EUR), que la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de "CB HOLDING S.A. (en liqui-
dation)", inscrite au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B 138887, ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449
Luxembourg, constituée par acte de Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 27 mai
2008 publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1508 du 18 juin 2008.
Les statuts de la société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte du notaire instrumentaire,
en date du 16 juin 2008, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1736 du 15 juillet 2008.
La société a été volontairement mise en liquidation par acte du notaire instrumentaire en date du 13 février 2014,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1212 du 13 mai 2014.
Par conséquent la liquidation de la société a été clôturée et la société est dissoute.
Les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq ans à partir du jour de la liquidation
auprès de FIDUCENTER S.A., ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, inscrite au R.C.S.Luxembourg
sous le numéro B62780.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juillet 2014.
Référence de publication: 2014109249/25.
(140131149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2014.
123563
L
U X E M B O U R G
Osborne & Moore S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 25.170.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014103415/9.
(140122659) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2014.
Green Europe Lux s.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8399 Windhof, 20, rue de l'Industrie.
R.C.S. Luxembourg B 160.715.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Windhof, le 18/07/2014.
Référence de publication: 2014104919/10.
(140125904) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2014.
Oz Holding S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 181.913.
Statuts coordonnés, suite à l’assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de rési-
dence à Esch/Alzette, en date du 6 janvier 2014 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 6 février 2014.
Référence de publication: 2014103403/11.
(140121750) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2014.
Perunna S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 131.275.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Perunna S.A.
i>Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.
Référence de publication: 2014103428/11.
(140121716) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2014.
Gohu S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 25, rue Philippe II.
R.C.S. Luxembourg B 178.955.
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration en date du 04 juillet 2014i>
- Le Conseil d'Administration a décidé de transférer le siège social de la Société du 18 rue Robert Stümper à L-2557
Luxembourg au 25 rue Philippe II à L-2340 Luxembourg et ce avec effet au 1
er
août 2014.
Luxembourg, le 04 juillet 2014.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2014104934/13.
(140125325) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2014.
123564
L
U X E M B O U R G
BJT S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 104.300,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 95.015.
Le bilan au 31.12.2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014105561/9.
(140126255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2014.
Azurline S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 15.000,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 164.711.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour AZURLINE S.à r.l.i>
Référence de publication: 2014105533/10.
(140126206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2014.
Partinvest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 39.118.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
CACEIS BANK / CACEIS BANK
Monique J.E. Lodewijckx / Jean-Pierre Valentini
<i>Company Secretary Departement / Company Secretaryi>
Référence de publication: 2014103443/12.
(140122599) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2014.
Hess (Luxembourg) Exploration and Production Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 133.158.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associée unique en date du 17 juillet 2014i>
1. M. Pietro LONGO a démissionné de son mandat de gérant de catégorie B.
2. La société à responsabilité limitée UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES SARL, RCS Luxembourg B n° 64474,
ayant son siège social à L- L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommée comme gérante de catégorie B
pour une durée indéterminée.
3. Le siège social a été transféré de L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte à L-2453 Luxem-
bourg, 6, rue Eugène Ruppert.
Veuillez noter que l'adresse professionnelle des gérants, Messieurs Pierre CLAUDEL et Christophe-Emmanuel SACRE
se trouve dorénavant à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
Luxembourg, le 17.7.2014.
Pour extrait et avis sincères et conformes
<i>Pour Hess (Luxembourg) Exploration and Production Holding S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.
Référence de publication: 2014104948/20.
(140125145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2014.
123565
L
U X E M B O U R G
Mohican S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.
R.C.S. Luxembourg B 146.779.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014103364/9.
(140121822) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2014.
NTT Cable Europe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8506 Redange-sur-Attert, 3, rue de Niederpallen.
R.C.S. Luxembourg B 160.348.
Der Jahresabschluss vom 31/12/2012 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014103396/9.
(140122286) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2014.
Bistro Dream S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3370 Leudelange, 2, Z.I. Grasbusch.
R.C.S. Luxembourg B 182.677.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>La gérancei>
Référence de publication: 2014105537/11.
(140126282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2014.
BIL Prime Advanced, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-4360 Esch-sur-Alzette, 14, Porte de France.
R.C.S. Luxembourg B 108.505.
L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s'est tenue le 18 juillet 2014:
- a nommé en tant qu'administrateur:
Monsieur Yves KUHN, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
pour une période d'un an prenant fin lors de la prochaine assemblée en 2015
- a renouvelé le mandat d'administrateur de:
Madame Nadège DUFOSSE, 136, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
Monsieur Vincent HAMELINK, Avenue des Arts 58, B-1000 Bruxelles
Monsieur Jean-Yves MALDAGUE, 136, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
Monsieur Alain PETERS, 136, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
CANDRIAM LUXEMBOURG, représentée par Jean-Yves MALDAGUE, 136, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
pour une période d'un an prenant fin lors de la prochaine assemblée en 2015
- a renouvelé le mandat de:
PricewaterhouseCoopers, RCS B-65477, 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, en tant que Réviseur d'Entreprises
pour une période d'un an prenant fin lors de la prochaine assemblée en 2015.
<i>Pour BIL PRIME ADVANCED
i>Société d'Investissement à Capital Variable
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.
Société Anonyme
Référence de publication: 2014105558/25.
(140126571) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2014.
123566
L
U X E M B O U R G
La Boqueria S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 2, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 179.748.
In the year two thousand and fourteen, the seventeenth day of June.
Before Maître Martine DECKER, notary residing in Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
- GGM Investments S.à.r.l., a limited liability company established under the laws of Luxembourg, established and having
its registered office at L-5365 Munsbach, 2, rue Gabriel Lippmann, filed with the Trade and Company Register in Luxem-
bourg under number B-154.746,
here represented by its sole manager Mr. Guillermo G. Morales Lopez, professionally residing at L-5365 Munsbach, 2,
rue Gabriel Lippmann,
being the sole shareholder of La Boqueria S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée)
incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2, rue Gabriel Lippmann,
L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of twelve thousand five hundred Euro (EUR
12,500.-) and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 179748 (the
«Company»).
The Company has been incorporated pursuant to a deed of the notary Henri Hellinckx, residing in Luxembourg, dated
August 14, 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 2552 of October 14, 2013,
the Articles of Incorporation of which have been modified pursuant to a deed of the same notary dated September 17,
2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 2936 of November 21, 2013.
The Sole Shareholder, as represented, has requested the officiating notary to record the following:
I. That the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company; and
II. That the Sole Shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend paragraph 4 of Article 12 of the Articles of Incorporation, as follows:
« Art. 12. (paragraph 4). The corporation is committed by the sole signature of the single Manager or, in case of plurality
of managers, by the joint signatures of two Managers or by the individual signature of the delegate of the board.»
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder revokes the mandate of the manager Mr. Hugo Aguado Cano.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder appoints for an unlimited duration as single Manager Mr. Juan Pedro López Montaño, born in
Cordoba (Spain), on 29 September 1978, residing professionally at L-5365 Munsbach, 2, rue Gabriel Lippmann
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appearing party,
in case of divergencies between the English and the French texts, the English version will prevail.
Whereof, the present notarial deed is drawn in Hesperange, on the year and day first above written.
The document having been read to the representative of the appearing party, known to the notary by his name,
surname, state and residence, he signed together with us, the notary, the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mil quatorze, le dix-sept juin.
Pardevant Maître Martine DECKER, notaire de résidence à Hesperange, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
- GGM Investments S.à.r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège
social à L-5365 Munsbach, 2, rue Gabriel Lippmann, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous le Numéro B 154.746,
ici représentée par son gérant unique Monsieur Guillermo G. Morales Lopez, demeurant professionnellement à L-5365
Munsbach, 2, rue Gabriel Lippmann,
étant l’associé unique de «La Boqueria S.à r.l.», une société à responsabilité limitée constituée selon le droit du Grand-
Duché de Luxembourg, dont le siège social est établi au 2, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de
Luxembourg, ayant un capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) immatriculée au Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 179748 (la «Société»).
123567
L
U X E M B O U R G
La Société a été constituée suivant acte reçu par le notaire Henri Hellinckx, de résidence à Luxembourg, en date du
14 août 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 2552 du 14 octobre 2013, les statuts
de laquelle ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire en date du 17 septembre 2013, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 2936 du 21 novembre 2013.
L'Associé Unique, tel que représenté, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Que l’Associé Unique détient la totalité des parts sociales dans le capital social de la Société; et
II. Que l’Associé Unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier l’alinéa 4 de l’article 12 des statuts, comme suit:
« Art. 12. (alinéa 4). La société est engagée par la seule signature du gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants,
par les signatures conjointes de deux gérants ou par la signature individuelle du délégué du conseil.»
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique révoque le mandat du gérant Monsieur Hugo Aguado Cano.
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé Unique nomme pour une durée indéterminée gérant unique Monsieur Juan Pedro López Montaño, né à
Cordoba (Espagne), le 29 septembre 1978, demeurant professionnellement à L-5365 Munsbach, 2, rue Gabriel Lippmann.
Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare que la partie comparante l’a requis de documenter le
présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête de la même partie, et en cas de divergence
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Hesperange.
Et après lecture faite au représentant de la partie comparante, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et
demeure, il a signé avec nous, Notaire, le présent acte.
Signé: Morales Lopez, M. Decker.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 20 juin 2014. Relation: LAC/2014/28661. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): Irène Thill.
POUR EXPÉDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Hesperange, le 14 juillet 2014.
Référence de publication: 2014103290/83.
(140121428) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2014.
PTL Holdings Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 36.000,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 63.102.
In the year two thousand and fourteen, on the tenth day of June.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
THERE APPEARED:
Penske Truck Leasing Co L.P., a limited partnership formed under the laws of the State of Delaware, having its regis-
tered office at 2711, Centerville Road, suite 400, Wilmington, USA - 19808 Delaware, registered with the Delaware
Register of Companies under number 216 70 14,
here represented by Sara Lecomte, private employee, with professional address in [Luxembourg],
by virtue of a proxy under private seal given on 29 April 2014 which has been signed ne varietur by the proxyholder
of the appearing party and the undersigned notary.
Such appearing party is the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of PTL HOLDINGS LUXEMBOURG SARL, a
private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg, having its registered office at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg and being registered
with the Luxembourg Register of Trade and Companies under number B 63.102 (the "Company"), incorporated by a
deed drawn up on 13 February 1998 by Maître Gérard Lecuit, notary public then residing in Hesperange, Grand Duchy
of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") under number 344
dated 14 May 1998, page 16488, and whose articles of association (the "Articles") were last amended pursuant to a deed
of the undersigned notary, dated 8 June 2006, published in the Mémorial under number 1860 dated 4 October 2006, page
89263.
123568
L
U X E M B O U R G
The agenda was the following:
<i>Agendai>
1. To resolve on the dissolution and liquidation of the Company.
2. To appoint Penske Truck Leasing Co., L.P., a limited partnership formed in the United States of America, having its
registered office at 2711, Centerville Road, suite 400, Wilmington, USA - 19808 Delaware, registered under number 216
70 14, as liquidator of the Company (the "Liquidator").
3. To determine the powers of the Liquidator.
4. Miscellaneous.
The appearing party, representing the whole corporate capital of the Company, requires the notary to enact the
following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to dissolve and put the Company into liquidation as of the date of the present deed.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to appoint the Liquidator as liquidator of the Company, which Liquidator has accepted
this mandate.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves that the Liquidator shall receive the powers determined hereafter:
- the Liquidator has the broadest powers as provided for by articles 144 to 148bis of the Luxembourg law of 10 August
1915 on commercial companies, as amended (the "1915 Law");
- the Liquidator may accomplish all the acts provided for by article 145 of the 1915 Law without requesting the
authorization of the Sole Shareholder in the cases in which it is required;
- the Liquidator may exempt the registrar of mortgages from proceeding with any automatic registration, renounce
all in rem rights, preferential rights, mortgages, actions for rescission, and remove any attachment, with or without
payment, of all the preferential or mortgaged registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other encum-
brance;
- the Liquidator is relieved from inventory and may refer to the accounts of the Company;
- the Liquidator may, under its responsibility and for special or specific operations, delegate to one or more proxies
such part of its powers as it determines and for the period it determines;
- the Liquidator may distribute to the Sole Shareholder an advance in cash or in kind on the proceeds of the liquidation;
- the Liquidator shall be liable, both to third parties and to the Company, for the execution of the mandate given to
it hereby;
- the Liquidator's signature binds validly and without limitation the Company in the process of liquidation;
- the Liquidator shall draft a report on the results of the liquidation and the employment of the corporate assets with
supporting accounts and documents.
<i>Costsi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed, are estimated at approximately one thousand two hundred Euros (EUR 1,200.-).
Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting is closed.
<i>Statementi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a French version, and that, at the request of the same appearing
person, in case of divergences between the English and the French version, the English version will be preponderant.
Whereof the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this
document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing person, known to the notary by her name, first
name, civil status and residence, said proxyholder signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille quatorze, le dixième jour du mois de juin;
Par devant Nous Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), sous-
signé.
A COMPARU:
123569
L
U X E M B O U R G
Penske Truck Leasing Co L.P., un limited partnership constitué selon les lois de l’état du Delaware, ayant son siège
social au 2711, Centerville Road, suite 400, Wilmington, USA - 19808 Delaware, immatriculée auprès du Delaware
Register of Companies sous le numéro 216 70 14,
ici représentée par Sara Lecomte, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 29 avril 2014 qui a été signée ne varietur par le mandataire de
la partie comparante et le notaire soussigné.
Laquelle partie comparante est l’associé unique (l’"Associé Unique") de PTL HOLDINGS LUXEMBOURG SARL, une
société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand Duché de Luxembourg, ayant son siège
social au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 63.102 (la "Société"), constituée selon un acte rédigé le 13 février 1998 par Maître
Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, Grand Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations (le "Mémorial") sous le numéro 344 en date du 14 mai 1998, page 16488, et dont les statuts (les
"Statuts") ont été modifiés pour la dernière fois par un acte du notaire soussigné, en date du 8 juin 2006, publié au Mémorial
sous le numéro 1860 en date du 4 octobre 2006, page 89263.
L'ordre du jour est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Décision de dissoudre et liquider la Société.
2. Decision de nommer Penske Truck Leasing Co L.P., un limited partnership constitué selon les lois des Etats-Unis,
ayant son siège social au 2711, Centerville Road, suite 400, Wilmington, USA - 19808 Delaware, immatriculée auprès du
Delaware Register of Companies sous le numéro 216 70 14, comme liquidateur de la Société (le "Liquidateur").
3. Déterminer les pouvoirs du Liquidateur.
4. Divers.
La partie comparante représentant l’intégralité du capital social de la Société a requis le notaire soussigné d'acter les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide de dissoudre et de mettre la Société en liquidation à compter de la date du présent acte.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique décide de nommer l’associé en tant que liquidateur de la Société et d'accepter ce mandat.
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé Unique décide que le Liquidateur recevra les pouvoirs comme déterminés ci-après:
- Le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi 1915").
- Le Liquidateur peut accomplir tous les actes prévus à l’article 145 de la Loi 1915 sans demander l’autorisation de
l’Associé Unique dans les cas où elle est requise.
- Le Liquidateur peut dispenser le conservateur des hypothèques de procéder à une inscription automatique, renoncer
à tous droits réels, droits préférentiels, hypothèques, actions résolutoires, et enlever les charges, avec ou sans paiement
de toutes les inscriptions préférentielles ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres charges;
- Le Liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.
- Le Liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou spécifiques, déléguer à un ou plusieurs
mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.
- Le Liquidateur pourra distribuer à l’Associé Unique une avance en numéraire ou en nature sur le boni de liquidation.
- Le Liquidateur sera responsable tant envers les tiers qu’envers la Société, pour l’exécution du mandat qui lui est
donné.
- La signature du Liquidateur lie valablement et sans limitation la Société dans le processus de liquidation.
- Le Liquidateur rédigera un rapport sur les résultats de la liquidation et sur l’emploi des actifs sociaux, comptes et
documents à l’appui.
<i>Coûts et dépensesi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, s'élève approximativement à mille deux cents euros (EUR
1.200,-).
Plus rien n'étant à l’ordre du jour et personne n'ayant soulevé d'autres points pour discussion par l’assemblée, l’as-
semblée est close.
123570
L
U X E M B O U R G
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande de la partie comparante, le
présent acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française, et que sur la demande de la même
partie comparante il est spécifié qu'en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais
prévaudra.
DONT acte notarié a été préparé à Luxembourg, le jour mentionné en haut de ce document.
Ce document ayant été lu au mandataire de la partie comparante, qui est connu du notaire par son nom de famille,
prénom, état civil et résidence, ledit mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: S. LECOMTE, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils le 12 juin 2014. Relation: LAC/2014/27179. Reçu soixante-quinze euros (EUR
75,-).
<i>Le Receveuri>
(signé): I. THILL.
Référence de publication: 2014106043/141.
(140126711) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2014.
Algos, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 111.472.
In the year two thousand and fourteen, on the fifteenth day of July.
Before us Me Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg was held an extraordinary general meeting of Algos,
a société à responsabilité limitée having its registered office at L-2449 Luxembourg, 8, Boulevard Royal, incorporated by
deed of Me Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, on 26 October 2005, published in Mémorial C Recueil des
Sociétés et Associations, number 1251, on 22 November 2005 (the “Company”). The articles of association of the
Company have been amended for the last time by deed of the notary Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem,
on 21 December 2005, published in Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, number 717, on 7 April 2006.
The meeting was presided by Mr Sylvain KIRSCH, private employee, professionally residing in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Mrs Marilyn KRECKÉ, private employee, professionally residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mrs Corinne PETIT, private employee, professionally residing in Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to state that:
I) It appears from an attendance list established and certified by the members of the bureau that the sole shareholder
of the Company is duly represented at this meeting.
II) The sole shareholder confirms through its proxyholder having knowledge of the agenda of the meeting and the
proxyholder waives, in the name and for the account of the shareholder, the convening formalities. Considering the above,
the sole shareholder may validly vote, through its proxyholder, with respect to its shares on all the items of the agenda
below.
The attendance list, signed by the proxyholder of the sole shareholder represented and the members of the bureau,
shall remain attached together with the proxy to the present deed and shall be filed at the same time with the registration
authorities.
The agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Change of the financial year of the Company.
2. Restatement of the articles of association of the Company.
The meeting took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting decides to change the fiscal year, so that the fiscal year shall run every year from the 1
st
day of
October until the 30
th
day of September,
and for the actual fiscal year 2014 from the first day of February until the 30
th
day of September 2014.
It is hereby resolved to amend article 20 of the articles of association of the Company to read as follows:
“The Company's year commences on October 1
st
of each year and ends on September 30
th
of the following year.”
It is hereby further resolved to amend article 21 of the articles of association of the Company to read as follows:
123571
L
U X E M B O U R G
“Each year on September 30
th
, the accounts are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory including an
indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory and balance
sheet at the Company's registered office.”
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder resolves to restate the articles of association of the Company in order to reflect the above and
to further include a German translation of the Company's articles of association accordingly, replacing the French trans-
lation. Henceforth, the articles of association of the Company shall read as follows:
“A. Purpose - Duration - Name - Registered office
Art. 1. There is hereby established by the current owner of the shares created hereafter and among all those who
may become partners in future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the «Company»)
which shall be governed by the law of August 10, 1915 concerning commercial companies, as amended, as well as by the
present articles of incorporation.
Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and
foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and
development of its portfolio.
An additional purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy
of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including the direct or indirect holding
of participation in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition, development, pro-
motion, sale, management and/or lease of real estate properties.
The Company may further guarantee, grant security in favour of third parties to secure its obligations or the obligations
of companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as
the Company, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which
form part of the same group of companies as the Company.
The Company may carry out any commercial, industrial, financial or intellectual property activities which it may deem
useful in accomplishment of these purposes.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.
Art. 4. The Company will assume the name of Algos.
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. The
registered office may be transferred within the same municipality by decision of the manager or, in case of several ma-
nagers, by the board of managers.
Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of
the manager or, in case of several managers, by the board of managers.
In the event that the manager or the board of managers determine that extraordinary political, economic or social
developments have occurred or are imminent, that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may
be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary mea-
sures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered
office, will remain a Luxembourg company.
B. Share Capital - Shares
Art. 6. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by five
hundred (500) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three quarters
of the share capital at least.
Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative
who shall represent them towards the Company.
Art. 9. The Company's shares are freely transferable among partners. Any inter vivos transfer to a new partner is
subject to the approval of such transfer given by the other partners, at a majority of three quarters of the share capital.
In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the
approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters of the share
capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the
surviving spouse.
123572
L
U X E M B O U R G
Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the
dissolution of the Company.
C. Management
Art. 11. The Company is managed by one or several managers, who need not be partners.
In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers has extensive powers
to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the
Company's purpose. The manager(s) is (are) appointed by the sole partner, or as the case may be, the partners, who fix
(es) the term of its/ their office. He (they) may be dismissed freely at any time by the sole partner, or as the case may be,
the partners.
The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one,
by individual signature of any manager.
Art. 12. In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which shall choose from among
its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who
need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of
meeting. The meetings of the board of managers shall be held at the registered office of the Company unless otherwise
indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside all meetings of the board of managers, but in his absence,
the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any
such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four (24) hours
in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be waived by consent in writing, by cable, telegram,
telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication. A separate notice will not be required for a board
meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.
No notice shall be required in case all the members of the board of managers are present or represented at a meeting
of such board of managers or in the case of resolutions in writing approved and signed by all the members of the board
of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or
facsimile, e-mail or any other similar means of communication another manager as his proxy. A manager may represent
more than one of his colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by other
similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation
in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented
at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or
represented at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication. The entirety will form the
minutes giving evidence of the resolution.
Art. 13. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by the
board of managers.
Art. 14. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the
Company.
Art. 15. The manager(s) do(es) not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to com-
mitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely
responsible for the execution of their mandate.
Art. 16. The manager or the board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of
accounts prepared by the manager or the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution,
it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal year,
increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.
D. Decisions of the sole partner - Collective decisions of the Partners
Art. 17. Each partner may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns. Each
partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
123573
L
U X E M B O U R G
Art. 18. Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are
adopted by partners owning more than half of the share capital.
The partners may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other
amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three quarters
of the share capital at least.
Art. 19. In the case of a sole partner, such partner exercises the powers granted to the general meeting of partners
under the provisions of section XII of the law of August 10, 1915 concerning commercial companies, as amended.
E. Financial Year - Annual Accounts - Distribution of Profits
Art. 20. The Company's year commences on October 1
st
of each year and ends on September 30
th
of the following
year.
Art. 21. Each year on September 30
th
, the accounts are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory including
an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory and balance
sheet at the Company's registered office.
Art. 22. Five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the partners.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,
who need not be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine their powers
and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets
and payment of the liabilities of the Company.
The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the
partners in proportion to the shares of the Company held by them.
Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of August 10, 1915 concerning commercial companies, as amended.”
There being no further business, the meeting was closed.
<i>Costsi>
The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it
by reason of the present deed are assessed at one thousand seven hundred Euro (EUR 1,700.-).
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the members of the
bureau, this deed is worded in English followed by a German translation. On request of the members of the bureau and
in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.
Whereof, this deed was drawn up in Luxembourg, on the date set at the beginning of this deed.
This deed having been read to the members of the bureau, all known to the notary by first and surname, civil status
and residence, they signed together with the notary the present deed.
Follows the german version
Im Jahre zweitausendundvierzehn, den fünfzehnten Juli.
Vor deR unterzeichneten NotarIN Martine SCHAEFFER, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg, ist der alleinige Ge-
sellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung Algos, mit Sitz in 8, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, zu einer
außerordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung Algos wurde gegründet gemäß notarieller Urkunde von Notar Jean-Joseph
WAGNER, mit Amtssitz in Sanem, vom 26. Oktober 2005, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, Nummer 1251 vom 22. November 2005 (die „Gesellschaft“). Die Satzung wurde zuletzt abgeändert gemäß
notarieller Urkunde des Notars Jean-Joseph WAGNER, mit Amtssitz in Sanem, vom 21. Dezember 2005, veröffentlicht
im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 717, vom 7. April 2006.
Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Herrn Sylvain KIRSCH, Angestellter, mit Geschäftsanschrift in Luxem-
burg, eröffnet.
Der Vorsitzende beruft zum Schriftführer Frau Marilyn KRECKÉ, Angestellte, mit Geschäftsanschrift in Luxemburg.
Die Versammlung wählt zum Stimmenzähler Frau Corinne PETIT, Angestellte, mit Geschäftsanschrift in Luxemburg.
Der Vorsitzende erklärt und ersucht den Notar zu diesem Zustand:
I) Es folgt aus der Anwesenheitsliste, vorbereitet bei und von den Mitgliedern des Präsidiums zertifiziert, dass der
alleinige Gesellschafter der Gesellschaft ordnungsgemäß in dieser Versammlung vertreten ist.
II) Der alleinige Gesellschafter bestätigt durch seinen Bevollmächtigten, dass sie die Kenntnis der Tagesordnung der
Sitzung hat und der Bevollmächtigte verzichtet, im Namen und für Rechnung des Gesellschafters, auf die Einberufungs-
123574
L
U X E M B O U R G
formalitäten. In Anbetracht der obigen darf der alleinige Gesellschafter, durch seinen Bevollmächtigten, alle Beschlüsse
fasst, die in Bezug auf ihre Anteile an allen Punkten der Tagesordnung erwähnt sind.
Die Anwesenheitsliste, die von dem Bevollmächtigten des einzigen Gesellschafter und der Mitgliedern des Präsidiums
unterzeichneten wurde, ist zusammen mit den Vollmachten bezüglich der gegenwärtigen Urkunde vorgelegt, und wird
zur gleichen Zeit den zuständigen Behörden eingereicht.
Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:
<i>Tagesordnungi>
1. Änderung des Geschäftsjahres der Gesellschaft.
2. Neuformulierung der Satzung der Gesellschaft.
Die Versammlung hat die folgenden Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt eine Änderung der Geschäftsjahres, sodass dieses jedes Jahr vom ersten
Oktober bis zum dreißigsten September laufen soll, und für das aktuelle Geschäftsjahr 2014 vom ersten Februar bis zum
dreißigsten September 2014.
Es wird hiermit beschlossen, Artikel 20 der Satzung der Gesellschaft abzuändern, so dass dieser wie folgt lautet:
„Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Oktober und endet am dreißigsten September des Folgejahres."
Es wird hiermit weiter beschlossen, den Artikel 21 der Satzung der Gesellschaft abzuändern, so dass dieser wie folgt
lautet:
„Jedes Jahr am 30. September wird ein Jahresabschluss erstellt und der Geschäftsführer oder die Geschäftsführer
bereiten ein Inventar der Aktiva und Verpflichtungen der Gesellschaft vor. Jeder Gesellschafter kann Einsicht in den
genannten Jahresabschluss am Sitz der Gesellschaft verlangen.“
<i>Zweiter Beschlussi>
Der alleinige Gesellschafter beschließt, die Satzung der Gesellschaft neu zu formulieren, um dem Vorstehenden Rech-
nung zu tragen und die deutsche Übersetzung der Satzung der Gesellschaft entsprechend einzufügen, welche die
französische Übersetzung ersetzt. Die Satzung der Gesellschaft wird künftig wie folgt lauten:
„A. Zweck - Dauer - Name - Sitz
Art. 1. Es wird hiermit durch den derzeitigen Inhaber der im Folgenden zu gründenden Anteile sowie für alle zukünftigen
Gesellschafter eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet (société à responsabilité limitée) (im Folgenden die
„Gesellschaft“), welche dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, wie abgeändert, sowie dieser
Satzung, unterliegt.
Art. 2. Der Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen, in welcher Form auch immer, in anderen Lu-
xemburger oder ausländischen Gesellschaften, und jede andere Form von Investitionen, der Erwerb durch Kauf,
Zeichnung oder auf andere Art und Weise als auch die Übertragung durch Verkauf, Tausch oder sonstigen von Wert-
papieren jeglicher Art sowie die Verwaltung, Kontrolle und Entwicklung dieser Beteiligungen.
Zusätzlich ist der Zweck der Gesellschaft der Erwerb und Verkauf von Immobilienvermögen, entweder im Großher-
zogtum Luxemburg oder im Ausland, sowie alle Aktivitäten, welche im Zusammenhang mit Immobilieninvestitionen
stehen, inklusive das direkte oder indirekte Halten von Beteiligungen an Luxemburger oder ausländischen Gesellschaften,
deren vorrangiger Zweck der Ankauf, die Entwicklung, Förderung, Veräußerung Verwaltung und/oder Leasing von Im-
mobilienvermögen ist.
Die Gesellschaft kann außerdem Garantien und Sicherheiten an Dritte ausstellen, um die Verpflichtung und die Ver-
pflichtungen von direkt oder indirekt verbundenen Unternehmen der Gesellschaft oder Gesellschaften desselben
Konzerns zu besichern, Darlehen ausgeben oder anderweitig die direkt oder indirekt verbundenen Unternehmen der
Gesellschaft oder Gesellschaften desselben Konzerns unterstützen.
Die Gesellschaft kann außerdem jegliche kommerzielle, industrielle, finanzielle sowie im geistigen Eigentum angesiedelte
Tätigkeit ausüben, welche sie als für das Erreichen des oben beschriebenen Unternehmenszwecks förderlich hält.
Art. 3. Die Gesellschaft ist auf unbeschränkte Dauer gegründet.
Art. 4. Die Gesellschaft wird die Bezeichnung Algos tragen.
Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg. Der Sitz kann innerhalb
derselben Gemeinde durch Beschluss des Geschäftsführers und im Falle von mehreren Geschäftsführern durch Beschluss
des Verwaltungsrates verlegt werden.
Filialen oder Dienststellen der Gesellschaft dürfen entweder in Luxemburg oder im Ausland, jeweils durch Beschluss
des Geschäftsführers und im Falle von mehreren Geschäftsführern durch Beschluss des Verwaltungsrates, gegründet
werden.
123575
L
U X E M B O U R G
Für den Fall dass der Geschäftsführer oder der Verwaltungsrat befindet, dass außerordentliche politische, wirtschaft-
lichen oder soziale Entwicklungen vorliegen oder bevorstehen, welche Einfluss auf die normalen Tätigkeiten der
Gesellschaften an deren Sitz haben oder welche die Kommunikation zwischen diesem Sitz und ausländischen Personen
stört, so kann der Sitz zeitlich befristet in das Ausland verlegt werden, bis die anormalen Umstände vollkommen beseitig
sind; solche zeitlich befristeten Maßnahmen sollen die Nationalität der Gesellschaft nicht beeinflussen, welche unabhängig
von einem zeitlich befristet Verlegen des Sitzes ins Ausland weiterhin eine Luxemburgische Gesellschaft bleibt.
B. Gesellschaftskapital - Anteile
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt ZWÖLFTAUSEND FÜNFHUNDERT EURO (EUR 12.500,-) und ist eingeteilt
in FÜNFHUNDERT (500) Anteile mit einem Nominalwert von je FÜNFUNDZWANZIG EURO (EUR 25.-).
Jeder Anteil berechtigt zur Abgabe einer Stimme bei den ordentlichen und außerordentlichen Gesellschafterversamm-
lungen.
Art. 7. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch Gesellschafterbeschluss, welcher mindestens drei Viertel des
Gesellschaftskapitals vertritt, geändert werden.
Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen Inhaber je Anteil an. Anteile, welche von mehreren Inhabern gehalten
werden, berufen einen einzelnen Vertreter, welcher sie gegenüber der Gesellschaft vertritt.
Art. 9. Gesellschaftsanteile können frei zwischen den Gesellschaftern übertragen werden. Die Übertragung von An-
teilen inter vivos an Nichtgesellschafter kann nur nach vorheriger Zustimmung von Gesellschaftern, welche mindestens
drei Viertel (3/4) des Kapitals vertreten, erfolgen.
Die Übertragung von Anteilen mortis causa an Nichtgesellschafter unterliegt der Zustimmung der Gesellschafter,
welche mindestens drei Viertel (3/4) des Kapitals vertreten. Eine solche Zustimmung ist jedoch nicht erforderlich, wenn
die Anteile an die Eltern, die Nachkommen, oder den Hinterbliebenen Partner erfolgt.
Art. 10. Das Fortbestehen der Gesellschaften wird durch Tod, Entzug der Bürgerrechte, Insolvenz oder Zahlungsun-
fähigkeit eines Gesellschafters nicht beeinträchtigt.
C. Verwaltung - Geschäftsführung
Art. 11. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern, welche Gesellschafter sein müssen, ver-
waltet.
Im Umgang mit Dritten hat der Geschäftsführer, oder im Fall von mehreren Geschäftsführern der Verwaltungsrat,
umfassende Rechte um im Namen der Gesellschaft und unter allen Umständen für diese zu handeln sowie Handlungen
und Tätigkeiten durchzuführen, welche im Einklang mit dem Zweck der Gesellschaft stehen. Der Geschäftsführer oder
Verwaltungsrat wird durch den alleinigen Gesellschafter oder, je nach Fall, von den Gesellschaftern, bestellt, welche(r)
die Dauer des Mandats festlegen. Er/sie kann/können jederzeit durch den alleinigen Gesellschafter oder, je nach Fall, durch
die Gesellschafter, abberufen werden.
Die Gesellschaft ist unter allen Umständen durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers oder, im Falle von
mehreren, durch die alleinige Unterschrift eines jeden Geschäftsführers gebunden.
Art. 12. Bei Vorliegen von mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch einen Verwaltungsrat geleitet,
welcher aus seiner Mitte einen Verwaltungsratsvorsitzenden bestellt und einen zweiten Verwaltungsratsvorsitzenden
wählen kann. Der Verwaltungsrat kann auch einen Schriftführer wählen, welcher kein Geschäftsführer sein muss, und
welcher für die Protokolle der Verwaltungsratssitzungen verantwortlich ist.
Der Verwaltungsrat wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei Geschäftsführer einberufen, welcher am in der
Mitteilung angegebenen Ort zusammentrifft. Die Verwaltungsratssitzungen finden am Sitz der Gesellschaft statt, sofern
nichts anderes in der Mitteilung bestimmt ist. Der Verwaltungsratsvorsitzende sitzt den Verwaltungsratssitzungen vor.
Bei dessen Abwesenheit kann der Verwaltungsrat durch Mehrheitsbeschluss der Anwesenden einen Vorsitzenden pro
tempore ernennen.
Die schriftliche Mitteilung über die Einberufung einer Verwaltungsratssitzung muss den Geschäftsführern mindestens
vierundzwanzig (24) Stunden vor der Sitzung zugestellt werden, außer für den Fall von Dringlichkeit, bei welchem die
Natur der Angelegenheit und die Gründe für die Dringlichkeit in der Mitteilung anzugeben sind. Auf die Mitteilung kann
schriftlich, per Telegramm, Telex oder Fax, E-Mail oder jegliche andere Form von Kommunikation verzichtet werden.
Eine separate Mitteilung ist für eine in einer vorigen Verwaltungsratssitzung beschlossene Sitzung nicht erforderlich.
Für den Fall dass alle Mitglieder des Verwaltungsrates bei einer Sitzung anwesend oder vertreten sind, oder dass
Umlaufbeschlüsse von allen Mitgliedern des Verwaltungsrates genehmigt und unterschrieben sind, ist keine Mitteilung
erforderlich.
Jeder Geschäftsführer kann sich bei einer Sitzung schriftlich, per Telegramm, Telex oder Fax, E-Mail oder durch jegliche
andere Form von Kommunikation von einem anderen Mitglied vertreten lassen. Ein Verwaltungsratsmitglied kann mehr
als einen seiner Kollegen vertreten.
Jeder Geschäftsführer kann bei einer Verwaltungsratssitzung durch Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch
jegliche andere Form von Kommunikation teilnehmen, die allen Personen erlaubt, die an der Sitzung teilnehmen, sich
123576
L
U X E M B O U R G
gegenseitig zu hören und voneinander gehört zu werden. Eine solche Teilnahme an einer Sitzung ist einer persönlichen
Teilnahme an der Sitzung gleichgestellt.
Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn zumindest die Mehrheit der Geschäftsführer bei der Verwaltungsratssit-
zung anwesend oder vertreten ist. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der bei der Sitzung anwesenden oder
vertretenen Geschäftsführer gefasst.
Die Geschäftsführer können einstimmig Umlaufbeschlüsse verabschieden, wenn die Zustimmung schriftliche, per Te-
legramm, Telex oder Fax, E-Mail oder durch jegliche andere Form von Kommunikation gegeben wurde. Die Gesamtheit
bildet das Protokoll, welches den gefassten Beschluss bezeugt.
Art. 13. Das Protokoll jeder Sitzung wird vom Vorsitzenden oder, bei dessen Abwesenheit, durch den zweiten Ver-
waltungsratsvorsitzenden oder gemeinsam durch zwei Mitglieder des Verwaltungsrates unterschrieben. Kopien oder
Auszüge der Protokolle, die in Gerichtsverfahren oder auf andere Weise hergestellt werden, werden vom Vorsitzenden
oder gemeinsam durch zwei Mitglieder des Verwaltungsrates unterzeichnet.
Art. 14. Der Tod oder der Rücktritt eines Geschäftsführer, unabhängig des Grundes dafür, führt nicht zur Auflösung
der Gesellschaft.
Art. 15. Der oder die Geschäftsführer hat/haben keine persönliche Haftung, aufgrund seines/ihres Mandates, in Bezug
auf eine Verpflichtung, die er/sie rechtsgültig im Namen der Gesellschaft festgelegt hat/haben. Sie sind nur bevollmächtigte
Stellvertreter und sind deshalb vor allem für die ordnungsgemäße Ausführung ihres Mandats verantwortlich.
Art. 16. Der Geschäftsführer oder der Verwaltungsrat kann auf Basis einer vom Geschäftsführer oder vom Verwal-
tungsrat erstellten Bilanz die Ausschüttung von Zwischendividenden beschließen, sofern ausreichend ausschüttbare
Geldmittel zur Verfügung stehen und unter der Voraussetzung dass die auszuschüttenden Beträge nicht die realisierten
Gewinne seit dem letzten Steuerjahr, erhöht um den Gewinnvortrag und ausschüttbare Reserven, jedoch verringert um
Verlustvorträge und Summen, welche per Gesetz oder durch die vorliegende Satzung einer Reserve zugeführt werden
sollen.
D. Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters - Gemeinsame Beschlüsse der Gesellschafter
Art. 17. Jeder Gesellschafter kann an der Gesellschafterversammlung teilnehmen, und dies unabhängig von der Anzahl
seiner Gesellschaftsanteile. Jeder Gesellschafter verfügt über Stimmrechte im Verhältnis zu seinen Gesellschaftsanteilen.
Art. 18. Abgesehen von in der Satzung festgelegten strengeren Mehrheiten, besitzen Beschlüsse der Gesellschafter-
versammlung ihre Gültigkeit nur, wenn mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals durch die Gesellschafter vertreten
ist.
Beschlüsse, welche die Ansässigkeit der Gesellschaft ändern, müssen durch einstimmigen Gesellschafterbeschluss ge-
troffen werden. Jegliche andere Änderung der Statuten bedarf einer Mehrheit der Gesellschafter, die mindestens drei
Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals vertreten.
Art. 19. Für den Fall eines alleinigen Gesellschafters kann dieser die der Gesellschafterversammlung gewährten Be-
fugnisse im Sinne von Abschnitt XII des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, in abgeänderter Form,
wahrnehmen.
E. Geschäftsjahr, Jahresabschluss, Gewinnverteilung
Art. 20. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Oktober und endet am dreißigsten September des
Folgejahres.
Art. 21. Jedes Jahr am 30. September wird ein Jahresabschluss erstellt und der Geschäftsführer oder die Geschäftsführer
bereiten ein Inventar der Aktiva und Verpflichtungen der Gesellschaft vor. Jeder Gesellschafter kann Einsicht in den
genannten Jahresabschluss am Sitz der Gesellschaft verlangen.
Art. 22. Jedes Jahr werden fünf Prozent (5%) des Nettogewinns dem gesetzlichen Reservefonds zugeführt, bis dieser
Reservefonds zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals umfasst. Der verbleibende Betrag kann frei an die Gesell-
schafter ausgeschüttet werden.
F. Auflösung - Liquidation
Art. 23. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren Liquidator(en) ausge-
führt, welche(r) kein(e) Gesellschafter sein muss/müssen und der/die von den Gesellschaftern ernannt wird/werden, die
wiederum seine Befugnisse und seine Vergütung festlegen. Sofern nicht anderweitig festgelegt, sollen die Liquidatoren die
am weitest gehenden Rechte besitzen, um die Aktiva zu veräußern und die Bezahlung der Verbindlichkeiten der Gesell-
schaft sicherzustellen.
Der durch die Veräußerung der Aktiva und nach Bezahlung der Verbindlichkeiten erzielte Überschuss wird anteilig an
die Gesellschafter ausgeschüttet.
Art. 24. Alles was nicht durch die gegenwärtige Satzung festgelegt ist, unterliegt den gesetzlichen Bestimmungen des
Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, in abgeänderter Form.“
123577
L
U X E M B O U R G
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung aufgehoben.
<i>Ausgabeni>
Die Kosten, Ausgaben, Entschädigungen oder ähnliche Gebühren in jeglicher Form, welche von der Gesellschaft als
Ergebnis der vorliegenden Urkunde zu tragen sind, werden auf ungefähr eintausendsiebenhundert Euro (EUR 1.700.-)
geschätzt.
Der unterzeichnende Notar, welcher die englische Sprache spricht und versteht, bestätigt hiermit, dass auf Anweisung
der Mitgliedern des Präsidiums die vorliegende Satzung in englischer Sprache gefolgt von einen deutschen Übersetzung
verfasst ist, und dass auf Hinweis denselben Mitgliedern des Präsidiums im Falle von inhaltlichen Unterschieden zwischen
den sprachlichen Versionen, die englische Version entscheidend sein soll.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxembourg, Datum wie am Anfang dieser Urkunde erwähnt.
Nachdem diese Urkunde den Mitgliedern des Präsidiums, welche dem unterzeichneten Notar durch Name, Nachname,
Familienstand und Anschrift bekannt sind, vorgelesen wurde, haben sie zusammen mit dem Notar diese Urkunde unter-
zeichnet.
Signé: S. Kirsch, M. Krecké, C. Petit et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 17 juillet 2014. LAC/2014/33621. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).
<i>Le Receveuri>
(signé): Irène Thill.
POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juillet 2014.
Référence de publication: 2014107303/384.
(140128449) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2014.
O.E.M. SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1473 Luxembourg, 2A, rue Jean-Baptiste Esch.
R.C.S. Luxembourg B 79.406.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014103400/9.
(140121712) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2014.
OZ Carbon Trading (Lux) S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 125.057.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014103416/9.
(140122544) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2014.
BBA sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5816 Hesperange, 3, Montée du Château.
R.C.S. Luxembourg B 161.320.
Le bilan au 31.12.2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juillet 2014.
Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L-1013 Luxembourg
Référence de publication: 2014106381/14.
(140127404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.
123578
L
U X E M B O U R G
Digital Services Holding XXIII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 188.606.
STATUTES
In the year two thousand and fourteen, on the first of July.
Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
THERE APPEARED:
Rocket Internet GmbH, a limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) existing under the laws of
Germany, registered with the commercial register at the local court of Charlottenburg, Germany, under no. HRB 109262
B, having its registered address at Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Germany,
here represented by Ms Alix van der Wielen, maître en droit, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a
proxy, given in Berlin, Germany on 15. May 2014.
Said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to
this deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party has requested the officiating notary to enact the deed of incorporation of a private limited
company (société à responsabilité limitée) which it wishes to incorporate with the following articles of association:
A. Name - Purpose - Duration - Registered office
Art. 1. Name - Legal Form. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name
Digital Services Holding XXIII S.à r.l. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915
concerning commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.
Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign
companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio in view of its realisation by sale, exchange or otherwise.
2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it
holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the
Company.
2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by
issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.
2.4 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities
which it considers useful for the accomplishment of these purposes.
Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of
managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution
of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution
of the board of managers.
4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances
or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
traordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwiths-
tanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.
123579
L
U X E M B O U R G
B. Share capital - Shares
Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), represented by twelve
thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.
5.2 The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
5.3 The Company may redeem its own shares.
Art. 6. Shares.
6.1 The Company’s share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of
the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.
Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection
by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.
7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall
appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.
7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given
by the shareholders at a majority of three quarters of the share capital.
7.5 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of
the transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.
7.6 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject
to the approval of such transfer given by the surviving shareholders at a majority of three quarters of the share capital.
Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving
spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.
C. Decisions of the shareholders
Art. 8. Collective decisions of the shareholders.
8.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles
of association.
8.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
8.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise
conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case,
each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his
vote in writing.
8.4 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of
shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by
the sole shareholder.
Art. 9. General meetings of shareholders. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, at least
one general meeting of shareholders shall be held within six (6) months of the end of each financial year in Luxembourg
at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the convening notice of such meeting.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices
of meeting. If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived
any convening requirement, the meeting may be held without prior notice or publication.
Art. 10. Quorum and vote.
10.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
10.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company’s
shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share
capital. If this majority is not reached in a first meeting or proposed written resolution, the shareholders may be convened
a second time with the same agenda or receive such proposed written resolution a second time by registered letter,
123580
L
U X E M B O U R G
decisions are validly adopted in so far as they are adopted by a majority of the votes validly cast whichever is the fraction
of the share capital represented.
Art. 11. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.
Art. 12. Amendments of the articles of association. Any amendment of the articles of association requires the approval
of (i) a majority of shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.
D. Management
Art. 13. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
13.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers
form a board of managers.
13.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not
expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of
association is to be construed as a reference to the “sole manager”.
13.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any
actions necessary or useful to fulfil the Company’s corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the
Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.
Art. 14. Appointment, removal and term of office of managers.
14.1 The manager(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remune-
ration and term of office.
14.2 The managers shall be appointed and may be removed from office at any time, with or without cause, by a decision
of the shareholders representing more than half of the Company’s share capital.
14.3 The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two (2) different classes, being class A
managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant
shareholders resolutions and the managers be identified with respect to the class they belong.
Art. 15. Vacancy in the office of a manager.
15.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or
otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the replaced manager by the remaining managers until the next meeting of shareholders which shall resolve on the
permanent appointment, in compliance with the applicable legal provisions.
15.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company’s sole manager, such vacancy must be filled without undue
delay by the general meeting of shareholders.
Art. 16. Convening meetings of the board of managers.
16.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held
at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.
16.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four (24) hours at
least in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document
being sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location
determined in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.
16.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive
any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of
managers.
Art. 17. Conduct of meetings of the board of managers.
17.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not
need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
17.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any
such meeting.
17.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either
in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.
17.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other
means of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis
and allowing an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a
participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.
123581
L
U X E M B O U R G
17.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or
represented at a meeting of the board of managers.
17.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,
if any, shall not have a casting vote. In the event where the general meeting of shareholders has appointed different classes
of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only be validly
taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which may be
represented).
17.7. The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in
writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be
the date of the last signature.
Art. 18. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
18.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by
the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. In the event the general meeting of
shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers), such minutes
shall be signed by one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation). Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman,
if any, or by any two (2) managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of
managers (namely class A managers and class B managers), such copies or excerpts shall be signed by one (1) class A
manager and one (1) class B manager (including by way of representation).
18.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.
Art. 19. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the
signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers;
in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers
and class B managers), the Company will only be validly bound by the joint signatures of at least one (1) class A manager
and one (1) class B manager (including by way of representation) or (ii) by the joint signatures or the sole signature of
any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such
delegation.
E. Audit and supervision
Art. 20. Auditor(s).
20.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company
shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.
20.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting
of shareholders.
20.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
20.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d’entreprises agréé
(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies’ register and the
accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.
20.5. An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its
approval.
F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends
Art. 21. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end
on the thirty-first of December of the same year.
Art. 22. Annual accounts and allocation of profits.
22.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of
the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.
22.2. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve.
This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten
per cent (10%) of the share capital of the Company.
22.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the
contributing shareholder agrees with such allocation.
22.4 In case of a share capital reduction, the Company’s legal reserve may be reduced in proportion so that it does
not exceed ten per cent (10%) of the share capital.
123582
L
U X E M B O U R G
22.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the
remainder of the Company’s profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.
22.6 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.
Art. 23. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
23.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared
by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may
not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable
reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles
of association do not allow to be distributed.
23.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the share-
holders subject to the provisions of the Law and these articles of association.
G. Liquidation
Art. 24. Liquidation.
24.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the
liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders
deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided,
the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the
Company.
24.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among
the shareholders in proportion to the number of shares of the Company held by them.
H. Final clause - Governing law
Art. 25. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance
with the Law.
<i>Transitional provisionsi>
1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 31 December
2014.
2. Interim dividends may be distributed during the Company’s first financial year.
<i>Subscription and paymenti>
The twelve thousand five hundred (12,500) shares issued have been subscribed by Rocket Internet GmbH, aforemen-
tioned, for the price of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.00).
The shares so subscribed are fully paid-up by a contribution in cash so that the amount of twelve thousand five hundred
euro (EUR 12,500) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
The total contribution in the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) is entirely allocated to the
share capital.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be
borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately EUR 1,500.-.
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
The incorporating shareholder, representing the entire share capital of the Company and having waived any convening
requirements, has thereupon passed the following resolutions:
1. The address of the registered office of the Company is set at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of
Luxembourg.
2. The following person is appointed as class A manager of the Company for an unlimited term:
- Mr Christian Senitz, born in Aschersleben, Germany, on 27 January 1978, professionally residing at Johannisstrasse
20, D-10117 Berlin.
The following person is appointed as class B manager of the Company for an unlimited term:
- Mr Ulrich Binninger, born in Trier, Germany, on 30 August 1966, professionally residing at 19, rue des Lilas, L-8035
Strassen, Luxembourg.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-
ment.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,
this deed is worded in English followed by a German translation; at the request of the same appearing party and in case
of divergence between the English and the German text, the English version shall prevail.
123583
L
U X E M B O U R G
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name
and residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:
Im Jahre zweitausendvierzehn, am ersten Juli.
Vor uns, Henri Hellinckx, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
IST ERSCHIENEN:
Rocket Internet GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach deutschem Recht, eingetragen im Handels-
register des Amtsgerichts Charlottenburg, unter der Nummer HRB 109262 B, mit Sitz in Johannisstrasse 20, 10117 Berlin
Deutschland,
hier vertreten durch Alix van der Wielen, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht
vom 15. Mai 2014, ausgestellt in Berlin, Deutschland.
Besagte Vollmacht, welche von der erschienenen Partei und dem unterzeichnenden Notar ne varietur paraphiert
wurde, wird der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.
Die erschienene Partei hat den amtierenden Notar ersucht, die Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung
(société à responsabilité limitée) zu beurkunden, welche sie mit der folgenden Satzung gründen möchte:
A. Name - Zweck - Dauer - Sitz
Art. 1. Name - Rechtsform. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée)
mit dem Namen Digital Services Holding XXIII S.à r.l. (die “Gesellschaft”), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom
10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung
unterliegt.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Ge-
sellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder
auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kontrolle
und Entwicklung ihrer Beteiligungen im Hinblick auf deren Verwertung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Art.
2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder
Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören Garantien geben,
Sicherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.
2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere
durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und
Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheine bzw. Wertpapieren.
2.4 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur vornehmen
sowie solche, welche das geistige Eigentum betreffen oder im Zusammenhang mit Grundeigentum stehen und die ihr zur
Erreichung dieser Zwecke förderlich erscheinen.
Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden,
welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird.
Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in der Stadt Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Rates der Geschäftsführer
verlegt werden. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderli-
chen Art und Weise gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.
4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer im
Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.
4.4 Sollte der Rat der Geschäftsführer entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale
Entwicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an
ihrem Gesellschaftssitz beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz bis zur endgültigen Beendigung dieser
außergewöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben
keine Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes
eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.
123584
L
U X E M B O U R G
B. Gesellschaftskapital - Anteile
Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) aufgeteilt in zwölf-
tausendfünfhundert (12.500) Anteile mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Anteil.
5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-
zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.
5.3 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen.
Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit jeweils dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht über-
schreiten darf.
6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs, die Insolvenz
oder ein vergleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.
Art. 7. Anteilsregister - Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden
kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.
7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten
wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft
ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.
7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.
7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern mit
einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden.
7.5 Jede Übertragung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten gemäß Artikel 1690 des Code Civil
wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung zugestimmt
hat.
7.6 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters an neue Gesellschafter nur mit Zustimmung von
Gesellschaftern mit einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden. Eine derartige Zu-
stimmung ist nicht erforderlich, wenn die Anteile an Eltern, Nachkommen oder den/die überlebende/n Ehepartner/in
übertragen werden oder jedem anderem gesetzlichen Erben des verstorbenen Gesellschafters.
C. Entscheidungen der Gesellschafter
Art. 8. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
8.1 Die Gesellschafterversammlung ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch das Gesetz und diese Satzung
übertragen wurden.
8.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.
8.3 Falls und solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, dürfen gemeinsame Ent-
scheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung vorbehalten wären, schriftlich gefasst werden. In diesem
Fall erhält jeder Gesellschafter den Text der Beschlüsse oder Entscheidungen in ausformulierter Form und übt sein
Stimmrecht schriftlich aus.
8.4 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschriften
des Abschnitts XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jeder Bezug auf die „Gesellschafter-
versammlung“ in der vorliegenden Satzung als Bezug auf den Alleingesellschafter, je nach Zusammenhang und soweit
anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingesellschafter ausgeübt.
Art. 9. Gesellschafterversammlung. Falls die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, muss jährlich
innerhalb von sechs (6) Monaten vor dem Ende des Geschäftsjahres mindestens eine Gesellschafterversammlung in Lu-
xemburg am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort abgehalten werden, wie in der Einberufungsbekanntmachung
zu dieser Versammlung genauer bestimmt. Andere Gesellschafterversammlungen finden an dem Ort und zu der Zeit statt,
welcher in der entsprechenden Einberufungsbekanntmachung genauer bestimmt werden. Falls alle Gesellschafter in einer
Versammlung anwesend oder vertreten sind und auf sämtliche Einberufungsformalitäten verzichtet haben, kann die Ge-
sellschafterversammlung auch ohne vorherige Ankündigung oder Veröffentlichung abgehalten werden.
Art. 10. Quorum und Abstimmung.
10.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.
123585
L
U X E M B O U R G
10.2 Vorbehaltlich anderer Regelungen dieser Satzung oder des Gesetzes, die ein höheres Mehrheitsverhältnis vor-
sehen, bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von Gesellschaftern, die mehr als die
Hälfte des Gesellschaftskapitals halten. Falls diese Mehrheit in einer ersten Gesellschafterversammlung oder einer ersten
schriftlichen Konsultation der Gesellschafter nicht erreicht wird, können die Anteilseigner ein weiteres Mal mit derselben
Tagesordnung einberufen werden oder per Einschreiben dieselben schriftlichen Beschlussvorschläge erhalten und Ent-
scheidungen werden wirksam mit der Mehrheit der wirksam abgegebenen Stimmen gefasst, unabhängig vom Anteil des
durch sie vertretenen Gesellschaftskapitals.
Art. 11. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.
Art. 12. Änderung der Satzung. Eine Änderung der Satzung erfordert die Zustimmung (i) einer Mehrheit der Gesell-
schafter, die mindestens (ii) eine Mehrheit von drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertritt.
D. Geschäftsführung
Art. 13. Befugnisse des alleinigen Geschäftsführers -Zusammensetzung und Befugnisse des Rates der Geschäftsführer.
13.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Ge-
schäftsführer hat, bilden diese einen Rat der Geschäftsführer.
13.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „alleiniger Ge-
schäftsführer“ nicht ausdrücklich verwendet wird, ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Rat der Geschäftsführer“
als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer“ auszulegen.
13.3 Der Rat der Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse im Namen der Gesellschaft zu handeln
und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.
Art. 14. Ernennung, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
14.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung ernannt, welche ihre Bezüge und
Amtszeit festlegt.
14.2 Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund durch einen Beschluss von Gesellschaftern, die mehr als die
Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, ernannt oder abberufen werden.
14.3 Die Gesellschafterversammlung kann die Ernennung von Geschäftsführern zwei (2) unterschiedlicher Kategorien
beschließen, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Eine solche Klassifizierung
der Geschäftsführer muss ordnungsgemäß im Protokoll der betreffenden Gesellschafterbeschlüsse festgehalten und die
Geschäftsführer der Kategorie, der sie angehören, zugeordnet werden.
Art. 15. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
15.1 Scheidet ein Geschäftsführer durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Insolvenz, Rücktritt oder aus einem anderen Grund
aus seinem Amt aus, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen die ur-
sprüngliche Amtszeit nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesellschafterversammlung ausgefüllt werden,
welche im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die endgültige Ernennung entscheidet.
15.2 Für den Fall, dass der alleinige Geschäftsführer aus seinem Amt ausscheidet, muss die frei gewordene Stelle
unverzüglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.
Art. 16. Einladung zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
16.1 Der Rat der Geschäftsführer versammelt sich auf Einberufung eines beliebigen Geschäftsführers. Die Sitzungen
des Rates der Geschäftsführer finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.
16.2 Die Geschäftsführer werden mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung anberaumten
Zeitpunkt zu jeder Sitzung des Rates der Geschäftsführer schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe
der Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Geschäftsführer
schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abgege-
ben haben, wobei eine Kopie eines solchen unterzeichneten Dokuments ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung
zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss
des Rates der Geschäftsführer bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.
16.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle
Einladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Rates
der Geschäftsführer diesen zugestimmt und diese unterzeichnen.
Art. 17. Durchführung von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
17.1 Der Rat der Geschäftsführer kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Rat der Ge-
schäftsführer kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise selbst ein Geschäftsführer sein muss
und der für die Protokollführung der Sitzungen des Rates der Geschäftsführer verantwortlich ist.
17.2 Sitzungen des Rates der Geschäftsführer werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Rates der Ge-
schäftsführer geleitet. In dessen Abwesenheit kann der Rat der Geschäftsführer ein anderes Mitglied des Rates der
123586
L
U X E M B O U R G
Geschäftsführer durch einen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Mitglieder als Vorsitzenden pro
tempore ernennen.
17.3 Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer teilnehmen, indem er ein anderen
Geschäftsführer schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder durch ein anderes vergleichbares Kommunikationsmittel be-
vollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Geschäftsführer kann einen
oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.
17.4 Eine Sitzung des Rates der Geschäftsführer kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein
anderes Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu
hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel
ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung gilt als am Sitz der Ge-
sellschaft abgehalten.
17.5 Der Rat der Geschäftsführer kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest die Mehrheit seiner
Mitglieder in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.
17.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Rates der Geschäftsführer
teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden,
hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme. Sofern die Gesellschafterversammlung jedoch unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden Beschlüsse des Rates der Geschäftsführer nur dann wirksam gefasst, wenn sie von der Mehrheit
der Geschäftsführer einschließlich mindestens eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsführers der
Kategorie B (oder deren Vertreter) gefasst werden.
17.7 Der Rat der Geschäftsführer kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung,
per Faxschreiben, E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Jeder Geschäftsführer kann seine
Zustimmung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreffenden
Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.
Art. 18. Protokoll von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer - Protokoll der Entscheidungen des alleinigen Ge-
schäftsführers.
18.1 Das Protokoll einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer wird vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer,
falls vorhanden oder, im Falle seiner Abwesenheit, vom Vorsitzenden pro tempore und dem Schriftführer (falls vorhanden)
oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche
Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kate-
gorie B), werden solche Protokolle durch einen (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einen (1) Geschäftsführer der
Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet. Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsver-
fahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer, falls
vorhanden, oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden solche Kopien oder Auszüge durch einen (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einen (1)
Geschäftsführer der Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet.
18.2 Die Entscheidungen des alleinigen Geschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom alleinigen
Geschäftsführer unterzeichnet wird. Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet.
Art. 19. Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Um-
ständen durch (i) die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder, für den Fall, dass die Gesellschaft mehrere
Geschäftsführer hat, durch die gemeinsame Unterschrift zwei (2) beliebiger Geschäftsführer wirksam verpflichtet; sofern
die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer
der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B), wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift min-
destens eines (1) Geschäftsführers der Kategorie A und eines (1) Geschäftsführers der Kategorie B (oder deren
Vertreter), oder (ii) durch die gemeinsamen Unterschriften oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/
denen eine Unterschriftsbefugnis durch den Rat der Geschäftsführer übertragen worden ist, wirksam verpflichtet.
E. Aufsicht und Prüfung der Gesellschaft
Art. 20. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
20.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der
Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)). Die Gesellschafterversammlung
ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.
20.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
20.3 Die Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Recht der permanenten Überprüfung und Kontrolle aller Ge-
schäfte der Gesellschaft.
20.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember
2002 betreffend das Handelsregister und die Buchhaltung und den Jahresabschluss von Unternehmen, in der jeweils
123587
L
U X E M B O U R G
gültigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d’entreprise agréé(s)) ernennen, entfällt
die Funktion des Rechnungsprüfers.
20.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die
Gesellschafterversammlung abberufen werden.
F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinne - Abschlagsdividenden
Art. 21. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am
einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.
Art. 22. Jahresabschluss und Gewinne.
22.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Rat der Geschäftsführer erstellt im
Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und
Verlustrechnung.
22.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage
der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.
22.3 Durch einen Gesellschafter erbrachte Einlagen in Rücklagen können mit Zustimmung dieses Gesellschafters
ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.
22.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage entsprechend herabgesetzt
werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.
22.5 Auf Vorschlag des Rates der Geschäftsführer bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den ge-
setzlichen Vorschriften und den Bestimmungen dieser Satzung wie der verbleibende Bilanzgewinn der Gesellschaft
verwendet werden soll.
22.6 Ausschüttungen an die Gesellschafter erfolgen proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehalt-
enen Anteile.
Art. 23. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
23.1 Der Rat der Geschäftsführer kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche
vom Rat der Geschäftsführer vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur
Verfügung stehen. Der ausschüttbare Betrag darf nicht die Summe der seit dem Ende des vergangenen Geschäftsjahres
angefallenen Gewinne, gegebenenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne und ausschüttbare Rücklagen, beziehungs-
weise vermindert durch vorgetragene Verluste oder Summen, die einer Rücklage zugeführt werden, welche nach dem
Gesetz von 1915 oder dieser Satzung nicht ausgeschüttert werden darf, übersteigen.
23.2 Das Agio, andere Kapitalreserven und andere ausschüttbare Rücklagen können, im Einklang mit den Bestimmungen
des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung, frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.
G. Liquidation
Art. 24. Liquidation.
24.1 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Abwicklung durch
einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, die über die
Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit nichts anderes
bestimmt wird haben die Liquidatoren die weitestgehenden Rechte für die Verwertung der Vermögenswerte und die
Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
24.2 Der sich nach Verwertung der Vermögenswerte und Tilgung der Verbindlichkeiten ergebende Überschuss wird
an die Gesellschafter proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehaltenen Anteile verteilt.
H. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht
Art. 25. Anwendbares Recht. Für alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten gelten die Regelungen des
Gesetzes von 1915.
<i>Übergangsbestimmungeni>
1. Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember
2014.
2. Abschlagsdividenden können auch während des ersten Geschäftsjahres der Gesellschaft ausgeschüttet werden.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Die zwölftausendfünfhundert (12 500) ausgegebenen Anteile wurden durch Rocket Internet GmbH, vorbenannt, zum
Preis von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) gezeichnet.
Die Einlage für so gezeichnete Anteile wurde vollständig in bar erbracht, so dass der Gesellschaft ein Betrag in Höhe
von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) zur Verfügung steht, was dem unterzeichnenden Notar nachgewiesen
wurde.
123588
L
U X E M B O U R G
Die gesamte Einlage von in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) wird vollständig dem Gesellschafts-
kapital zugeführt.
<i>Auslageni>
Die der Gesellschaft aufgrund oder im Zusammenhang mit ihrer Gründung entstandenen Kosten, Gebühren, Honorare
und Auslagen werden auf EUR 1.500,- geschätzt.
<i>Beschlüsse des Alleingesellschaftersi>
Der Gründungsgesellschafter, welcher das gesamte Gesellschaftskapital repräsentiert und welcher auf eine formelle
Einberufungsbekanntmachung verzichtet, hat daraufhin folgende Beschlüsse gefasst:
1. Der Sitz der Gesellschaft ist in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
2. Die folgende Person wird für unbegrenzte Zeit als Geschäftsführer der Kategorie A der Gesellschaft ernannt:
- Herr Christian Senitz, geboren am 27. Januar 1978 in Aschersleben, Deutschland, geschäftsansässig in Johannisstrasse
20, D-10117 Berlin.
Die folgende Person wird für unbegrenzte Zeit als Geschäftsführer der Kategorie B der Gesellschaft ernannt:
- Herr Ulrich Binninger, geboren am 30. August 1966 in Trier, Deutschland, geschäftsansässig in 19, rue des Lilas,
L-8035 Strassen, Luxemburg.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg am eingangs erwähnten Datum.
Der beurkundende Notar, welcher die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit auf Ersuchen der erschienenen
Partei, dass diese Urkunde auf Anfrage der erschienenen Partei auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen
Übersetzung. Auf Ersuchen derselben erschienenen Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen
und dem deutschen Text, soll die englische Fassung vorrangig sein.
Nachdem das Dokument dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei verlesen wurde, welche dem Notar mit Na-
men, Vornamen und Wohnsitz bekannt ist, hat der Bevollmächtigte die Urkunde zusammen mit dem Notar unterzeichnet.
Gezeichnet: A. VAN DER WIELEN und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 juillet 2014. Relation: LAC/2014/32065. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri>
(signé): I. THILL.
- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - Der Gesellschaft auf Begehr erteilt.
Luxemburg, den 15. Juli 2014.
Référence de publication: 2014103022/570.
(140122371) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2014.
Dominium Topco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 188.716.
STATUTES
In the year two thousand and fourteen, on the seventeenth day of the month of July.
Before Maître Cosita Delvaux, notary, residing in Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
BRE/Europe 7NQ S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited liability company) incorporated under the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, having
a share capital of twelve thousand and five hundred Euros (EUR 12,500) and being registered with the Registre de Com-
merce et des Sociétés in Luxembourg under number B 180.314,
represented by Ms Sandra Mohand-Oussaïd, lawyer, professionally residing in Luxembourg pursuant to a proxy dated
on 17 July 2014, which shall be registered together with the present deed.
The appearing party, acting in the above stated capacity, has requested the undersigned notary to draw up the articles
of incorporation of a limited liability company Dominium Topco S.à r.l. (société à responsabilité limitée) which is hereby
established as follows:
Art. 1. Denomination. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name “Dominium Topco
S.à r.l.” (the “Company”) is hereby formed by the appearing party and all persons who will become shareholders the-
reafter. The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.
Art. 2. Object. The object of the Company shall be the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg
and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
123589
L
U X E M B O U R G
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and
development of its portfolio.
The Company may also carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of real estate,
properties and real estate rights in Luxembourg and abroad as well as any participations in any real estate enterprise or
undertaking in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those participa-
tions and assets.
The Company may further give guarantees, grant security interests, grant loans or otherwise assist the companies in
which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may also acquire loans including at a discount, originate loans and lend funds under any form, advance
money or give credit on any terms including without limitation resulting from any borrowings of the Company or from
the issue of any equity or debt securities of any kind to any person or entity as it deems fit in relation to any real estate
enterprise or undertaking. The Company may enter into swaps, futures, forwards, derivatives, options, repurchase, stock
lending and similar transactions, and, without prejudice to the generality of the foregoing, employ any techniques and
instruments in connection with its real estate activities. The Company may also enter into any guarantees, contracts of
indemnities, security interests and any other equivalent agreements in order to receive the benefit of any guarantee and/
or security interest granted in the context of such real estate activities. The Company may undertake any roles necessary
in connection with such lending activity including, without limitation, the role of arranger, lead manager, facility agent,
security agent, documentation agent. The Company shall not undertake such real estate lending or real estate loan
acquisition activities in a way that would require it to be regulated pursuant to the Luxembourg act dated 5 April 1993
on the financial sector, as amended or any future act or regulation amending or replacing such act.
The Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or indirectly
in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purposes.
In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their admi-
nistration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other
advisors.
Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period.
Art. 4. Registered Office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an
extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles of
association.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the
case may be the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the manager, or as the case may be the board of managers, should determine that extraordinary
political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances;
such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified
to any interested parties by the manager or as the case may be the board of managers.
Art. 5. Share capital. The issued share capital of the Company is set at twelve thousand and five hundred Euros (EUR
12,500) represented by five hundred (500) shares with a nominal value of twenty-five Euros (EUR 25) each. The capital
of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for
amendment of these articles of association and the Company may proceed to the repurchase of its other shares upon
resolution of its shareholders.
Any available share premium shall be distributable.
Art. 6. Transfer of Shares. Shares are freely transferable among shareholders. Except if otherwise provided by law, the
share transfer to non-shareholders is subject to the consent of shareholders representing at least seventy-five per cent
(75%) of the Company's share capital.
Art. 7. Management of the Company. The Company is managed by one or several managers who do not need to be
shareholders.
In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers.
The sole manager or as the case may be, the board of managers, is vested with the broadest powers to manage the
business of the Company and to authorise and/or perform all acts of disposal and administration falling within the purposes
of the Company. All powers not expressly reserved by the law or by the articles of association to the general meeting
shall be within the competence of the sole manager or as the case may be, the board of managers.
123590
L
U X E M B O U R G
Vis-à-vis third parties the sole manager or as the case may be, the board of managers, has the most extensive powers
to act on behalf of the Company in all circumstances and to do, authorise and approve all acts and operations relative to
the Company and not reserved by law or these articles of association to the general meeting of shareholders.
The managers are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of share-
holders, which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed
for an undetermined period. The managers may be re-elected but their appointment may also be revoked with or without
cause (ad nutum) at any time.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means
of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one
another. A meeting may also at any time be held by conference call or similar means only. The participation in, or the
holding of, a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting
in person. Managers may be represented at meetings of the board by another manager without limitation as to the number
of proxies which a manager may accept and vote.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours (24) at
least in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by cable, telegram, telex, e-mail or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening
notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted
by the board of managers.
Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company.
The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman of that meeting or, in its absence,
by any two managers. Copies or excerpts of such minutes shall be signed by the chairman of that meeting or by any two
managers.
The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means
when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety
will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including circular
resolutions, may be conclusively certified or an extract thereof may be issued under the individual signature of any
manager.
The Company will be bound by the sole signature in the case of a sole manager, and in the case of a board of managers
by the sole signature of anyone of the managers. In any event the Company will be validly bound by the sole signature of
any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by the sole manager (if there is only
one) or as the case may be the board of managers or anyone of the managers.
Art. 8. Liability of the Managers. The manager(s) are not held personally liable for the indebtedness of the Company.
As agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties.
Subject to the exceptions and limitations listed below, every person who is, or has been, a manager or officer of the
Company shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against all
expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding which he becomes
involved as a party or otherwise by virtue of his being or having been such manager or officer and against amounts paid
or incurred by him in the settlement thereof. The words "claim", "action", "suit" or "proceeding" shall apply to all claims,
actions, suits or proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words "liability"
and "expenses" shall include without limitation attorneys' fees, costs, judgements, amounts paid in settlement and other
liabilities.
No indemnification shall be provided to any manager or officer:
(i) against any liability to the Company or its shareholders by reason of wilful misfeasance, bad faith, gross negligence
or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office;
(ii) with respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated to have acted in bad faith and not in
the interest of the Company; or (iii) in the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of
competent jurisdiction or by the board of managers.
The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any manager
or officer may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such manager or officer
and shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein shall
affect any rights to indemnification to which corporate personnel, including directors and officers, may be entitled by
contract or otherwise under law.
Expenses in connection with the preparation and representation of a defence of any claim, action, suit or proceeding
of the character described in this article shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof upon receipt
of any undertaking by or on behalf of the officer or director, to repay such amount if it is ultimately determined that he
is not entitled to indemnification under this article.
Art. 9. Shareholder voting rights. Each shareholder may take part in collective decisions. He has a number of votes
equal to the number of shares he owns and may validly act at any meeting of shareholders through a special proxy.
123591
L
U X E M B O U R G
Art. 10. Shareholder meetings. Decisions by shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as pre-
scribed by Luxembourg Company law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings. Any regularly constituted
meeting of shareholders of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the entire
body of shareholders of the Company.
Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to shareholders to their address appearing
in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire
share capital of the Company is represented at a meeting, the meeting may be held without prior notice.
In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the shareholders at their addresses
inscribed in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days before the proposed effective date
of the resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for
collective decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous
written resolution may be passed at any time without prior notice.
Except as otherwise provided for by law, (i) decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by
shareholders representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting or
first written resolution, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions
shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented. (ii) However, decisions
concerning the amendment of the articles of association are taken by (x) a majority of the shareholders (y) representing
at least three quarters of the issued share capital and (iii) decisions to change of nationality of the Company are to be
taken by Shareholders representing one hundred percent (100%) of the issued share capital.
At no time shall the Company have more than thirty (30) shareholders. At no time shall an individual be allowed to
become a shareholder of the Company.
Art. 11. Accounting Year. The accounting year begins on 1
st
January of each year and ends on 31
st
December of the
same year save for the first accounting year which shall commence on the day of incorporation and end on 31
st
December
2014.
Art. 12. Financial Statements. Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the
manager or, as the case may be, the board of managers.
The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.
Art. 13. Distributions. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction
ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.
The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the manager,
or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood
that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by
profits carried forward and distributable reserves and premium but decreased by losses carried forward and sums to be
allocated to a reserve to be established by law.
The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal
reserve account.
Art. 14. Dissolution. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators
who may be but do not need to be shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders who will
specify their powers and remunerations.
Art. 15. Sole Shareholder. If, and as long as one shareholder holds all the shares of the Company, the Company shall
exist as a single shareholder company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10
th
August 1915 on commercial com-
panies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.
Art. 16. Applicable law. For anything not dealt with in the present articles of association, the shareholders refer to the
relevant legislation.
<i>Subscription and paymenti>
The articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the appearing party has
subscribed and entirely paid-up the following shares:
Subscriber
Number
of shares
Subscription
price (EUR)
BRE/Europe 7NQ S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
EUR 12,500
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
EUR 12,500
Evidence of the payment of the total subscription price has been shown to the undersigned notary.
123592
L
U X E M B O U R G
<i>Expenses, Valuationi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately one thousand four hundred Euros (EUR 1,400).
<i>Extraordinary general meetingi>
The sole shareholder has forthwith taken immediately the following resolutions:
1. The registered office of the Company is fixed at: 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
2. The following person is appointed manager of the Company for an undetermined period of time subject to the
articles of association of the Company with such signature powers as set forth in the articles of association of the Company:
- BRE/Management 7 S.A., a société anonyme incorporated under the laws of Luxembourg, with registered office at
2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg and being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in
Luxembourg under number B 180.304.
3. The ratification of (i) the proxy dated on 17 July 2014 granted by BRE/Europe 7NQ S.à r.l. on behalf of the Company
for the purpose of the incorporation of Dominium Pledgeco S.à r.l.; (ii) the decision to incorporate Dominium Pledgeco
S.à r.l. and (iii) the subscription by the Company to five hundred (500) shares having a nominal value of twenty-five Euros
(EUR 25.00) representing the entire share capital of Dominium Pledgeco S.à r.l.
Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day before mentioned.
The document having been read to the appearing party, who requested that the deed should be documented in English,
the said appearing party signed the present original deed together with the notary, having personal knowledge of the
English language. The present deed, worded in English, is followed by a translation into German. In case of divergences
between the English and the German text, the English version will prevail.
The document having been read to the appearing party, known to the notary by its name, first name, civil status and
residence, the said appearing party signed together with the notary the present deed.
Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:
Im Jahre zweitausendvierzehn, am siebzehnten Tag des Monats Juli,
Vor dem unterzeichnenden Notar Maître Cosita Delvaux, mit Amtssitz in Redange-sur-Attert, Großherzogtum Lu-
xemburg,
ist erschienen,
BRE/Europe 7NQ S.à r.l., eine société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) luxemburgischen
Rechts mit Sitz in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, deren Gesellschaftskapital zwölftausendfünfhundert Euro
(EUR 12.500) beträgt, und eingetragen ist im Registre de commerce et des sociétés in Luxemburg unter der Nummer B
180.314,
hier vertreten durch Fräulein Sandra Mohand-Oussaïd, Juristin, beruflich wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer pri-
vatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt am 17. Juli 2014, welche vorliegender Urkunde beigefügt ist um mit dieser bei der
Registrierungsbehörde eingereicht zu werden.
Die erschienene Partei hat in ihrer vorgenannten Eigenschaft den unterzeichnenden Notar ersucht, die Gründungs-
satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) "Dominium Topco S.à r.l." wie folgt
zu beurkunden.
Art. 1. Gesellschaftsname. Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen
"Dominium Topco S.à r.l." (die "Gesellschaft") wird hiermit von der erschienenen Partei und allen Personen, die gegebe-
nenfalls zukünftig als Gesellschafter eintreten, gegründet. Die Gesellschaft wird durch vorliegende Satzung und durch die
entsprechende luxemburgische Gesetzgebung geregelt.
Art. 2. Gesellschaftszweck. Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen in jeder beliebigen Form an in-
und ausländischen Gesellschaften sowie jede andere Form von Investitionen, sowie den Erwerb durch Kauf, Zeichnung
oder andere Art und Weise wie Übertragung durch Verkauf oder Tausch von Finanzinstrumenten jeder Art und die
Verwaltung, Aufsicht und Entwicklung ihres Portfolios.
Die Gesellschaft kann ebenfalls alle Transaktionen welche sich auf direkten oder indirekten Erwerb von Grundbesitz,
Eigentum, und Grundbesitzrechte in Luxemburg oder im Ausland oder auf den Erwerb von Beteiligungen an Unternehmen
welche im Besitz von Grundrechten sind oder von Unternehmensbeteiligungen jedweder Form beziehen, durchführen
sowie die Verwaltung, Aufsicht und Entwicklung dieser Beteiligungen und dieses Vermögen ausführen.
Die Gesellschaft kann Bürgschaften geben, Sicherheiten leisten, Darlehen ausgeben oder die Gesellschaften an denen
die Gesellschaft direkte oder indirekte Beteiligungen besitzt oder die zur Gruppe von Gesellschaften gehört, der die
Gesellschaft angehört, in jeder anderen Form unterstützen.
Die Gesellschaft kann außerdem in jeder beliebigen Form Darlehen erwerben, auch mit Preisnachlass, Darlehen ver-
geben, Kapital verleihen, sowie Vorschüsse gewährleisten oder unter jeglichen Konditionen Kredite vergeben, einschließ-
lich und ohne Einschränkungen derer Kredite, in Bezug auf ein Immobilien-Unternehmen oder -Unterfangen, die sich von
123593
L
U X E M B O U R G
jeglichen Kreditaufnahmen der Gesellschaft oder von der Ausgabe von Kapital oder Schuldtitel jeglicher Art an alle Per-
sonen und Unternehmen, für die es für richtig empfunden wurde, ergeben. Die Gesellschaft kann Swaps, Futures,
Forwards, derivative Instrumente, Optionen, Rückkäufe, Wertpapierverleihe und ähnliche Transaktionen abschließen und
unbeschadet der Allgemeingültigkeit des Vorstehenden, jegliche Methode und Instrumente im Zusammenhang mit ihren
Immobiliengeschäften einsetzen. Die Gesellschaft kann auch jegliche Verträge über Garantien, Entschädigungen, Sicher-
heiten und alle weiteren äquivalente Verträge abschließen, so dass der Nutzen der, im Rahmen solcher Immobilienge-
schäfte vergebenen, Garantien und/oder Sicherheiten ihr zu Gute kommen kann. Die Gesellschaft kann im Rahmen solcher
Immobiliengeschäfte jegliche erforderliche Rolle übernehmen, einschließlich und ohne Einschränkungen der Rolle des
Arranger, lead Manager, Facility Agent, Security Agent, Documentation Agent. Die Gesellschaft wird die Tätigkeit der
Immobilienfinanzierung oder des Immobilienkrediterwerbs nicht in einer Weise ausüben, die eine Regulierung erfordern
würde gemäß der geänderten Fassung des Gesetzes des 5. Aprils 1993 bezüglich des Finanzsektors oder jeglichen zu-
künftigen Gesetzes oder Regulierungsmaßnahme, die dieses Gesetz abändern oder ersetzen sollte.
Die Gesellschaft kann alle geschäftlichen, technischen, finanziellen ebenso wie alle andere direkt oder indirekt ver-
bundenen Tätigkeiten welche die Erfüllung des Geschäftszwecks in den oben genannten Bereichen erleichtern, vorneh-
men.
Unter anderem wird die Gesellschaft allen Gesellschaften ihres Portfolios die für die Verwaltung, Entwicklung und
Aufsicht dieser Gesellschaften notwendigen Leistungen zur Verfügung stellen. Für diesen Zweck kann die Gesellschaft die
Unterstützung anderer Berater beanspruchen und auf solche zurückgreifen.
Art. 3. Geschäftsdauer. Die Gesellschaft ist auf unbegrenzte Dauer gegründet.
Art. 4. Gesellschaftssitz. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg. Dieser kann,
durch Beschluss einer außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter die sich, in der für die Abänderung der
Satzung vorgesehenen Art und Weise beraten, an jeden Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.
Der eingetragene Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss des Geschäftsführers, beziehungsweise durch die Ge-
schäftsführung innerhalb der Gemeinde verlegt werden.
Die Gesellschaft kann Geschäfts- und Zweigstellen in Luxemburg und im Ausland errichten.
Sollte der Geschäftsführer, oder im Falle einer Geschäftsführung die Geschäftsführung, feststellen, dass außerordent-
liche politische, wirtschaftliche oder soziale Ereignisse eingetreten sind oder unmittelbar bevorstehen welche die
normalen Tätigkeiten der Gesellschaft an ihrem eingetragenen Sitz oder die problemlose Kommunikation zwischen die-
sem Sitz und Personen im Ausland beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zum
vollständigen Ende solcher ungewöhnlichen Umstände ins Ausland verlegt werden; derartige vorläufige Maßnahmen haben
keine Auswirkung auf die staatliche Zugehörigkeit der Gesellschaft, die unbeschadet einer solchen vorübergehenden
Sitzverlegung eine luxemburgische Gesellschaft bleibt. Solche vorübergehenden Maßnahmen werden vom Geschäftsführer
oder, im Falle einer Geschäftsführung, von der Geschäftsführung vorgenommen und jeglichen betroffenen Personen mit-
geteilt.
Art. 5. Gesellschaftskapital. Das ausgegebene Gesellschaftskapital der Gesellschaft beläuft sich auf zwölftausendfünf-
hundert Euro (EUR 12.500), eingeteilt in fünf hundert (500) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je fünfund-
zwanzig Euro (EUR 25).
Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter in der für die Abänderung der
Satzung vorgesehenen Art und Weise erhöht oder verringert werden und die Gesellschaft kann seine anderen Gesell-
schaftsanteile durch Beschluss der Gesellschafter zurückkaufen.
Verfügbare Anteilsprämien können verteilt werden.
Art. 6. Übertragung der Anteile. Die Anteile sind unter den Gesellschaftern frei übertragbar. Soweit es das Gesetz
nicht anders bestimmt, bedarf die Übertragung von Anteilen auf Dritte der Einwilligung von Gesellschaftern, welche
zusammen mindestens fünfundsiebzig Prozent (75%) des Gesellschaftskapitals halten.
Art. 7. Geschäftsführung. Die Geschäftsführung der Gesellschaft erfolgt durch einen oder mehrere Geschäftsführer
die keine Gesellschafter sein müssen.
Im Falle mehrerer Geschäftsführer bilden diese die Geschäftsführung.
Der alleinige Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung ist mit den weitestreichenden Befugnissen aus-
gestattet, das Geschäft der Gesellschaft zu verwalten und ist dazu befugt, jede Handlungen und Tätigkeiten, die mit dem
Gegenstand der Gesellschaft im Einklang stehen, zu genehmigen und/oder auszuführen. Sämtliche Befugnisse, die nicht
ausdrücklich per Gesetz oder durch die vorliegende Satzung den Gesellschaftern vorbehalten sind, fallen in den Zustän-
digkeitsbereich des Geschäftsführers beziehungsweise der Geschäftsführung.
Gegenüber Dritten hat der Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung die weitestreichenden Befugnisse
um in allen Umständen, im Namen und Auftrag der Gesellschaft zu handeln und in jeden Umständen, jeden Akt und jede
Handlung, welche nicht durch die vorliegende Satzung oder durch die entsprechende luxemburgische Gesetzgebung im
Kompetenzbereich der Gesellschafterversammlung liegt, im Auftrag der Gesellschaft vorzunehmen, zu erlauben und gut-
zuheißen.
123594
L
U X E M B O U R G
Die Geschäftsführer werden durch mehrheitlichen Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter gewählt und
abberufen, welche ihre Befugnisse und die Amtsdauer beschließt. Wenn keine Frist gesetzt wird, dann sind die Geschäfts-
führer auf unbestimmte Zeit ernannt. Die Geschäftsführer können wiedergewählt werden, jedoch kann ihre Ernennung
zu jeder Zeit mit oder ohne Grund (ad nutum) widerrufen werden.
Jeder Geschäftsführer kann an jeder Sitzung der Geschäftsführung teilnehmen mittels Telefonkonferenz oder anderen
zur Verfügung stehenden Kommunikationsmitteln insofern gewährleistet ist, dass alle an der Sitzung teilnehmenden Per-
sonen sich hören und miteinander kommunizieren können. Eine Sitzung kann jederzeit mittels einer Telefonkonferenz
oder ähnlichen Kommunikationsmitteln abgehalten werden. Die Teilnahme oder das Abhalten einer Sitzung mit Hilfe
dieser Mittel entspricht einer persönlichen Teilnahme an der betroffenen Sitzung. Die Geschäftsführer können sich in den
Sitzungen ohne Einschränkung der Anzahl der Vollmachten durch einen anderen Geschäftsführer, der hierzu bevoll-
mächtigt ist, vertreten lassen.
Die Geschäftsführer sind mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor Beginn einer Sitzung der Geschäftsführung
mittels schriftlicher Einberufung, zu benachrichtigen, außer in Notfällen, in welchem Fall die Art und die Gründe dieser
Umstände in der Einberufung erläutert werden müssen. Auf das Recht auf die oben beschriebene Weise einberufen zu
werden kann jeder Geschäftsführer durch schriftliche Zustimmung per Telegramm, Telekopie, Email, Telefax oder per
ähnlichem Kommunikationsmittel verzichten. Spezifische Einberufungen sind nicht notwendig für Sitzungen, welche vorher
zu einem durch Geschäftsführungsbeschluss genehmigten Zeitplan und zu vorgesehenen Zeiten und an vorbestimmten
Orten abgehalten werden.
Entscheidungen der Geschäftsführung werden durch die Mehrheit der Geschäftsführer der Gesellschaft gefasst.
Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden der Sitzung oder, in seiner Abwesenheit,
von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Protokolle werden vom Vorsitzenden oder von
zwei Geschäftsführern unterzeichnet.
Schriftliche Beschlüsse der Geschäftsführung können, aus einem einzigen oder mehreren einzelnen Dokumenten, gültig
abgeschlossen werden, wenn sie von allen Mitgliedern der Geschäftsführung schriftlich, per Telegramm, Telefax oder per
ähnlichem Kommunikationsmittel genehmigt wurden. Die verschiedenen Dokumente gleichen Inhalts bilden zusammen
einen gültigen schriftlichen Beschluss. Beschlüsse der Geschäftsführung, einschließlich schriftliche Beschlüsse, können von
einem einzelnen Geschäftsführer beweiskräftig beglaubigt und ein Auszug davon beweiskräftig unterschrieben werden.
Die Gesellschaft wird durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder durch die Unterschrift eines einzel-
nen Geschäftsführers im Falle einer Geschäftsführung gebunden. Die Gesellschaft ist in jedem Fall wirksam durch die
Unterschrift einer oder mehrerer hierzu durch den alleinigen Geschäftsführer, beziehungsweise durch die Geschäftsfüh-
rung oder einer der Geschäftsführer, bevollmächtigten Personen, gebunden.
Art. 8. Haftung der Geschäftsführung. Die Geschäftsführer sind für Verschuldung der Gesellschaft nicht persönlich
haftbar. Als Vertreter der Gesellschaft sind sie jedoch für die Ausführung ihrer Aufgaben und Pflichten verantwortlich.
Vorbehaltlich den unten aufgeführten Ausnahmen und Beschränkungen, wird jede Person, die ein Geschäftsführer oder
leitender Angestellter der Gesellschaft ist oder war, von der Gesellschaft in vollem, gesetzlich erlaubten, Umfang gegen
Verbindlichkeiten und gegen alle Ausgaben, welche üblicherweise entstanden sind oder von ihm gezahlt wurden in Ver-
bindung mit Klagen, Prozessen oder Verfahren in die er als Partei oder anderweitig eintritt aufgrund dessen, dass er ein
Geschäftsführer oder leitender Angestellter ist oder gewesen ist und die diesbezüglich gezahlten Beträge oder von durch
deren Beilegung entstandenen Beträge, schadlos gehalten werden. Die Begriffe „Klage“, „Streitsache“, „Prozess“ oder
„Verfahren“ finden auf alle anhängigen oder bevorstehenden Klagen, Streitsachen, Prozesse oder Verfahren Anwendung
(zivilrechtlich, strafrechtlich oder sonstige, einschließlich Rechtsmittel) Anwendung und die Begriffe „Verbindlichkeit“ und
„Ausgaben“ beinhalten ohne Beschränkung Anwaltskosten, Prozesskosten, Sicherheitsleistungen, gezahlte Beträge bei
Streitbeilegung und andere Verbindlichkeiten.
Einem Geschäftsführer oder leitendem Angestellten wird keine Schadloshaltung gewährt:
(i) gegen Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschaft oder ihrer Gesellschafter, aufgrund von vorsätzlich begangenen
unerlaubten Handlungen, Bösgläubigkeit, grober Fahrlässigkeit oder rücksichtsloser Missachtung der Aufgaben, die in
seiner Amtsführung enthalten sind;
(ii) im Zusammenhang mit jeglichen Verfahren bei welchen er wegen bösgläubigem und nicht im Interesse der Gesell-
schaft erfolgtem Handeln, verurteilt wurde; oder
(iii) im Falle einer Beilegung, es sei denn die Beilegung ist von einem Gericht unter zuständiger Gerichtsbarkeit oder
von der Geschäftsführung genehmigt worden.
Das Recht der Schadloshaltung, das hier vorgesehen ist, ist abtrennbar und berührt keine anderen Rechte auf die das
Verwaltungsratsmitglied oder der leitende Angestellte jetzt oder später ein Anrecht hat, und soll fortgeführt werden in
der Person, die aufgehört hat, ein Geschäftsführer oder leitender Angestellter zu sein und soll dem Vorteil der Erben,
Testamentsvollstreckern und Verwaltern einer solchen Person dienen. Nichts hierin Enthaltenes berührt die Rechte zur
Schadloshaltung, auf die Gesellschaftspersonal, eingeschlossen Geschäftsführer und leitende Angestellte, aufgrund von
Vertrag oder anderweitig durch Gesetz, Anspruch haben könnten.
Ausgaben in Verbindung mit Vorbereitung und Vertretung der Verteidigung einer Klage, Streitsache, Prozess oder
Verfahren beschrieben in diesem Artikel, soll von der Gesellschaft vor der endgültigen Verfügung darüber bei Zugang
123595
L
U X E M B O U R G
jeglicher Unternehmung seitens oder im Namen eines leitenden Angestellten oder Geschäftsführers vorgestreckt werden,
um den benannten Betrag zurückzuzahlen wenn es letztlich bestimmt ist, dass er keinen Anspruch auf Schadloshaltung
unter diesem Artikel hat.
Art. 9. Stimmrechte der Gesellschafter. Jeder Gesellschafter kann an kollektiven Entscheidungen teilnehmen. Die Zahl
seiner Stimmen entspricht der Zahl seiner Gesellschaftsanteile und der Gesellschafter kann bei jeder Versammlung durch
eine spezielle Vollmacht vertreten werden.
Art. 10. Gesellschafterversammlungen. Die Beschlüsse der Gesellschafter werden in der im luxemburgischen Gesell-
schaftsrecht vorgeschriebenen Form und mit der darin vorgesehenen Mehrheit, schriftlich (soweit dies gesetzlich möglich
ist) oder in Gesellschafterversammlungen, gefasst. Jede ordnungsgemäß konstituierte Gesellschafterversammlung der
Gesellschaft beziehungsweise jeder ordnungsgemäß schriftlicher Beschluss vertritt die Gesamtheit der Gesellschafter der
Gesellschaft.
Die Einberufung der Versammlungen durch den Geschäftsführer/die Geschäftsführung hat mindestens acht (8) Tage
vor der Versammlung mittels eingeschriebenen Briefes an die Gesellschafter an ihre im Anteilsregister der Gesellschaft
eingetragene Adresse, zu erfolgen. Wenn das gesamte Gesellschaftskapital der Gesellschaft vertreten ist, kann die Sitzung
ohne vorherige Einberufung abgehalten werden.
Werden Beschlüsse im Wege eines Zirkularbeschlusses der Gesellschafter gefasst, so wird der Inhalt des Beschlusses
mindestens acht (8) Tage bevor der Beschluss wirksam werden soll, an alle Gesellschafter an ihre im Anteilsregister
eingeschriebene Adresse mittels eingeschriebenen Briefs übersandt. Die Beschlüsse werden wirksam bei Zustimmung
der vom Gesetz vorgesehenen Mehrheiten für gemeinsame Entscheidungen (oder, unter der Voraussetzung der Befrie-
digung der Mehrheitsvoraussetzungen, am in dieser Entscheidung festgelegten Tag). Einstimmige Zirkularbeschlüsse
können jederzeit ohne vorherige Ankündigung getroffen werden.
Soweit gesetzlich nichts anderes vorgesehen ist, (i) werden die in den Gesellschafterversammlungen zu fassenden
Beschlüsse von den Gesellschaftern getroffen, welche mehr als die Hälfte des Geschäftskapitals vertreten. Wird eine
solche Mehrheit bei der ersten Gesellschafterversammlung nicht erreicht, werden die Gesellschafter per Einschreiben zu
einer zweiten Gesellschafterversammlung geladen und die Beschlüsse werden sodann aufgrund der Mehrheit der abge-
gebenen Stimmen gefasst, unbeschadet der Anzahl der vertretenen Geschäftsanteile. (ii) Die Satzung kann jedoch nur mit
Zustimmung (x) der Mehrheit der Gesellschafter, welche (y) zwei Drittel des Gesellschaftskapitals vertreten, abgeändert
werden und (iii) Entscheidungen, die Nationalität der Gesellschaft zu ändern, bedürfen der Zustimmung von Gesellschaf-
tern, die einhundert Prozent (100%) des Gesellschaftskapitals vertreten.
Zu keiner Zeit soll die Gesellschaft mehr als dreißig (30) Gesellschafter haben. Zu keiner Zeit soll es einer natürlichen
Person gestattet sein, ein Gesellschafter der Gesellschaft zu werden.
Art. 11. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten (1.) Januar und endet am einunddreißigsten (31.) Dezember
eines jeden Jahres. Das erste Geschäftsjahr, welches am Tage der Gründung der Gesellschaft beginnt, wird am 31. De-
zember 2014 enden.
Art. 12. Jahresabschluss. Der alleinige Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung erstellt jedes Jahr die
Jahresabrechnung der Gesellschaft.
Jeder Gesellschafter kann die Jahresabrechnung am Sitz der Gesellschaft einsehen.
Art. 13. Gewinnverwendung Fünf. Prozent (5%) des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft werden der gesetzlich
vorgeschriebenen Rücklage zugeführt. Diese Rücklageeinzahlungspflicht besteht nicht mehr, sobald die gesetzliche Rück-
lage zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.
Die Gesellschafter können auf der Grundlage eines von dem alleinigen Geschäftsführer, beziehungsweise der Ge-
schäftsführung angefertigten Zwischenabschlusses die Ausschüttung von Abschlagsdividenden beschließen, sofern dieser
Zwischenabschluss zeigt, dass ausreichend Gewinne und andere Reserven zur Ausschüttung zur Verfügung stehen, wobei
der auszuschüttende Betrag die seit dem Ende des vorhergehenden Geschäftsjahres erzielten Gewinne, für welches die
Jahresabschlüsse bereits bewilligt wurden, erhöht um die vorgetragenen Gewinne und ausschüttbaren Rücklagen, ver-
mindert um die vorgetragenen Verluste und die der gesetzlichen Rücklage zuzuführenden Beträge, nicht übersteigen darf.
Der Saldo kann nach Entscheidung der Gesellschafterversammlung an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.
Das Anteilsprämienkonto kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung an die Gesellschafter ausgeschüttet
werden. Die Gesellschafterversammlung kann beschließen, jeden Betrag vom Anteilsprämienkonto auf die gesetzliche
Rücklage zu übertragen.
Art. 14. Auflösung. Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft ernennen die Gesellschafter einen oder mehrere Liqui-
datoren, bei welchen es sich nicht um Gesellschafter handeln muss, zwecks der Durchführung der Auflösung und
bestimmen ihre Befugnisse und Vergütung.
Art. 15. Alleingesellschafter. Sofern nur ein Gesellschafter alle Geschäftsanteile der Gesellschaft hält, gilt Artikel 179
(2) des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften und die Artikel 200-1 und 200-2 finden u.a. Anwendung.
Art. 16. Anwendbares Recht. Sämtliche nicht ausdrücklich durch diese Satzung geregelten Angelegenheiten richten
sich nach den entsprechenden Regelungen des anwendbaren Gesetzes.
123596
L
U X E M B O U R G
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Nach dem die erschienene Partei die Gründungssatzung erstellt hat, hat sie das gesamte Gesellschaftskapital wie folgt
eingezahlt und gezeichnet:
Einzahler
Zahl der
Geschäftsanteile
Einzahlungspreis
(EUR)
BRE/Europe 7NQ S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
EUR 12.500
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
EUR 12.500
Ein Beleg für die vollständige Einzahlung der Geschäftsanteile wurde dem unterzeichneten Notar vorgelegt.
<i>Kostenschätzungi>
Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund der vorlie-
genden Gesellschaftsgründung entstehen, werden auf ungefähr vierzehnhundert Euro (EUR 1.400) geschätzt.
<i>Ausserordentliche Beschlüsse des Gesellschaftersi>
Unverzüglich nach der Gründung der Gesellschaft hat der Alleinige Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:
1. Sitz der Gesellschaft ist in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg.
2. Die folgende Person wird für einen unbeschränkten Zeitraum zum Geschäftsführer der Gesellschaft mit der in der
Satzung der Gesellschaft beschriebenen Unterschriftsbefugnis ernannt:
- BRE/Management 7 S.A., eine Aktiengesellschaft (société anonyme) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 2-4, rue
Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg und eingetragen im Registre de Commerce et des Sociétés in Luxemburg unter der
Nummer B 180.304.
3. Die Ratifizierung der (i) Vollmacht vom 17. Juli 2014 bewilligt durch BRE/Europe 7NQ S.à r.l. im Namen der Ge-
sellschaft zwecks der Gründung von Dominium Pledgeco S.à r.l.; (ii) die Entscheidung, Dominium Pledgeco S.à r.l zu
gründen und (iii) die Zeichnung durch die Gesellschaft von fünfhundert (500) Aktien mit einem Nominalwert von fünf-
undzwanzig Euro (EUR 25.00), die das gesamte Grundkapital von Dominium Pledgeco S.à r.l. darstellen.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnende Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass auf Ersuchen der oben erschie-
nenen Partei, die vorliegende Urkunde in English abgefasst wird, gefolgt von einer deutschen Übersetzung.
Auf Ersuchen derselben erschienenen Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deut-
schen Text, ist die englische Fassung maßgebend.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die erschienene Partei die dem amtierenden Notar nach
Namen, Vornamen, Zivilstand und Wohnort bekannt, hat dieselbe zusammen mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.
Gezeichnet: S. MOHAND-OUSSAÏD, C. DELVAUX.
Enregistré à Redange/Attert, le 18 juillet 2014. Relation: RED/2014/1573. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): T. KIRSCH FUER.
GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum Zwecke
der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Redange-sur-Attert, den 18. Juli 2014.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2014104797/460.
(140125954) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2014.
LF Hotels Acquisition S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 55, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 165.946.
L'an deux mille quatorze, le deux avril.
Par-devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
«LF Hotels Acquico I S.C.S.», une société en commandite simple, ayant son siège social au 55, avenue Pasteur, L-2311
Luxembourg, immatriculé au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 175.791, représenté
par son gérant associé commandité «LF Hotels Acquico I (GP) S.à r.l.», une société à responsabilité limitée, ayant son
siège social au 55, Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés à Lu-
xembourg sous le numéro B 155.838,
ici représentée par Mlle Virginie PIERRU, employée privée, demeurant professionnellement à L-2740 Luxembourg, en
vertu de deux procurations données sous seing privé en date du 20 mars 2014.
123597
L
U X E M B O U R G
Laquelle procuration, après avoir été paraphée «ne varietur» par la mandataire de la comparante et le notaire instru-
mentant, restera annexée aux présentes pour les besoins de l'enregistrement.
Laquelle comparante, représentée comme ci-avant, est la seule associée («l'Associée Unique») de «LF Hotels Acqui-
sition S.à r.l.», une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 55, Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 22 novembre
2011, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 430 le 17 février 2012,
immatriculée au registre de commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 165.946.
Laquelle comparante, représentée comme ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associée Unique décide de réduire le capital social de la Société d'un montant d'un million quatre cent treize mille
euros (1.413.000.- EUR), pour le porter de son montant actuel de soixante-quatorze millions trois cent trente-deux mille
euros (74.332.000.- EUR) divisé en cent vingt-cinq (125) parts sociales ordinaires et trois cent soixante-et-onze mille cinq
cent trente-cinq (371.535) parts sociales préférentielles, ayant une valeur nominale de deux cents euros (200,- EUR)
chacune, à soixante-douze millions neuf cent dix-neuf mille euros (72.919.000,- EUR).
Cette réduction de capital social est réalisée par remboursement à l'Associée Unique du montant d'un million quatre
cent treize mille euros (1.413.000.- EUR) par annulation de sept mille soixante-cinq (7.065) parts sociales préférentielles
ayant une valeur nominale de deux cents euros (200,- EUR) chacune.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de ce qui précède, l'Associée Unique modifie l'article 5 des statuts comme suit:
Version anglaise:
“The corporate capital of the company is fixed at seventy-two million nine hundred and nineteen thousand Euro (EUR
72,919,000.-) represented by three hundred sixty-four thousand five hundred and ninety-five (364,595) shares divided
into one hundred twenty-five (125) ordinary non-redeemable shares (the Ordinary Non-Redeemable Shares) and three
hundred sixty-four thousand fort hundred and seventy (364,470) redeemable preference shares (the Redeemable Prefe-
rence Shares),having a nominal value of two hundred Euro (EUR 200.-) each, all subscribed and fully paid-up.”
Version allemande:
“Das Gesellschaftskapital ist auf vierundsiebzig Millionen drei hundert zwei und dreißig tausend Euro (EUR
72.919.000,-) festgesetzt, aufgeteilt in drei hundert einundsiebzig tausend sechs hundert sechzig (364,595) Anteile, un-
terteilt in einhundertfünfundzwanzig (125) nicht rückkaufbare Stammanteile (die nicht rückkaufbaren Stammanteile) und
drei hundert einundsiebzig tausend fünfhundert fünf und dreißig (364,470) rückkaufbare Anteile (die rückkaufbaren An-
teile), alle mit einem Nominalwert von zweihundert Euro (EUR 200,-) gezeichnet und voll eingezahlt.“
<i>Troisième résolutioni>
L'associée unique confère au gérant tous pouvoirs pour donner effet à la résolution ci-dessus, notamment de prendre
toutes mesures indiquées aux fins de remboursement du capital à l'associé unique par voie de paiement en espèces ou
en nature, toutefois en respectant les dispositions de l'article 69 (2) de la loi sur les sociétés commerciales et de prendre
toutes mesures nécessaires et utiles en relation avec la réduction du capital social.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
à raison des présentes est évalué à environ mille euros (1.000,-EUR).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
L'acte ayant été lu à la mandataire de la comparante, connue du notaire par ses nom, prénom usuel, état civil et
demeure, elle a signé avec le notaire, le présent acte.
Signé: V. PIERRU, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., LE 03.04.2014. Relation: LAC/2014/15628. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR COPIE CONFORME, délivré au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.
Luxembourg, le 03.04.2014.
Référence de publication: 2014103311/64.
(140122038) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2014.
123598
L
U X E M B O U R G
LPFE Soparfi A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 6.547.000,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 87.197.
In the year two thousand and fourteen, on the fourth of July.
Before US, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
LPFE Soparfi B S. à r.l., a “société à responsabilité limitée”, having its registered office in L-2540 Luxembourg, 26-28,
rue Edward Steichen, R.C.S. Luxembourg, number B 87.198, duly represented by its manager IREIM Services Luxembourg
S.à r.l., with registered office in L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey,
hereby represented by Mrs Corinne PETIT, private employee, with professional address at 74, Avenue Victor Hugo,
L-1750 Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg, on July 2
nd
, 2014.
The said proxy, signed “ne varietur” by the appearing party and the undersigned notary, shall be annexed to the present
deed for the purpose of registration.
The appearing party, acting in its capacity as the sole shareholder, has requested the undersigned notary to enact the
following:
The appearing party is the sole shareholder of "LPFE Soparfi A S.à r.l.", a limited liability company with registered office
in L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen, incorporated by deed of Maître Jean-Joseph WAGNER, notary
residing in Sanem, Grand-Duchy of Luxembourg, on April 26
th
, 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, number 1083 dated July 16
th
, 2002. These Articles of Association have been amended for the last time
by deed of the undersigned notary, on September 19
th
, 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, number 2643 dated October 25
th
, 2012.
The capital of the company is fixed at six million four hundred and eighty-three thousand euro (EUR 6,483,000)
represented by six thousand four hundred and eighty-three (6,483) shares, with a nominal value of one thousand euro
(EUR 1,000) each, being entirely paid up.
The appearing party takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder resolves to increase the corporate capital by an amount of sixty-four thousand euro (EUR
64,000), so as to raise it from its present amount of six million four hundred and eighty-three thousand euro (EUR
6,483,000) to six million five hundred and forty-seven thousand euro (EUR 6,547,000), by issuing sixty-four (64) new
shares with a par value of one thousand euro (EUR 1,000) each, having the same rights and obligations as the existing
shares.
<i>Subscription and liberationi>
The appearing sole partner LPFE Soparfi B S.à r.l. declares to subscribe the sixty-four (64) new shares and to pay them
up, fully in cash, at its par value of one thousand euro (EUR 1,000), so that the amount of sixty-four thousand euro (EUR
64,000) is at the free disposal of the Company, proof of which has been given to the undersigned notary.
<i>Second resolutioni>
The appearing sole partner resolves to amend article 6 of the articles of incorporation, so as to reflect the increase
of capital, which shall henceforth have the following wording:
" Art. 6. The capital is set at six million five hundred and forty-seven thousand euro (EUR 6,547,000) represented by
six thousand five hundred and forty-seven (6,547) shares of a par value of one thousand euro (EUR 1,000) each."
The undersigned notary who understands and speaks English, states that upon request of the above appearing party,
this deed is worded in English followed by a French translation and that in case of any divergence between the English
and the French text, the English text shall be prevailing.
Whereof, this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day appearing at the beginning of this document.
The document having been read and translated to the appearing persons, the appearing persons signed together with
the notary the present original deed.
Suit la version française
L'an deux mille quatorze, le quatre juillet.
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
123599
L
U X E M B O U R G
LPFE Soparfi B S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-2540 Luxembourg, 26-28, rue
Edward Steichen, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 87.198, dûment représentée
par son gérant IREIM Services Luxembourg S.à r.l.., avec siège social à L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey,
ici représentée par Madame Corinne PETIT, employée privée, avec adresse professionnelle au 74, Avenue Victor Hugo,
L-1750 Luxembourg, en vertu d'une procuration délivrée à Luxembourg, le 2 juillet 2014.
Laquelle procuration, après avoir été signé "ne varietur" par les comparantes et le notaire instrumentant, restera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Laquelle comparante, agissant en sa qualité d'associée unique, a requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui
suit:
La société comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée «LPFE Soparfi A S.à r.l.», avec siège
social à L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen, constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER,
notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 26 avril 2002, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 1083 du 16 juillet 2002 dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte
reçu par le notaire instrumentaire, en date du 19 septembre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, numéro 2643 du 25 octobre 2012.
Le capital social de la société est fixé à six millions quatre cent quatre-vingt-trois mille euros (6.483.000.- EUR) re-
présenté par six mille quatre cent quatre-vingt-trois (6.483) parts sociales d'une valeur nominale de mille euros (1.000.-
EUR) chacune.
L'associée unique prend les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'associée unique décide d'augmenter le capital social de la société d'un montant de soixante-quatre mille euros
(64.000.- EUR) afin de le porter de son montant actuel de six millions quatre cent quatre-vingt-trois mille euros
(6.483.000.- EUR) à six millions cinq cent quarante-sept mille euros (6.547.000.- EUR), par l'émission de soixante-quatre
(64) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de mille euros (1.000.-EUR) chacune, ayant les mêmes droits et
obligations que les parts sociales existantes.
<i>Souscription et libérationi>
Et à l'instant, les soixante-quatre (64) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de mille euros (1.000.- EUR) ont
été souscrites par l'associée unique LPFE Soparfi B S.à r.l. et entièrement libérée en espèces, de sorte que le montant de
soixante-quatre mille euros (64.000.- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu'il a été justifié
au notaire instrumentant.
<i>Deuxième résolutioni>
L'associé unique décide, suite à la résolution précédemment prise, de modifier l'article 6 des statuts qui aura désormais
la teneur suivante:
“ Art. 6. Le capital social est fixé à un montant de six millions cinq cent quarante-sept mille euros (6.547.000.- EUR)
représenté par six mille cinq cent quarante-sept (6.547) parts sociales d'une valeur nominale de mille euros (1.000.- EUR)
chacune.“
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la comparante, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française et qu'en cas de divergences entre le texte anglais et la
traduction française, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires de la partie comparante, connus du notaire par noms,
prénoms usuels, état et demeure, ils ont signé avec le notaire la présente minute.
Signé: C. Petit et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 juillet 2014. LAC/2014/32015. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).
<i>Le Receveuri> (signée): Irène Thill.
POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juillet 2014.
Référence de publication: 2014103316/103.
(140121665) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2014.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
123600
Algos
Azurline S.à r.l.
Bahian S.à r.l.
Base-Invest S.A.
Baumert,s.à r.l.
BBA sàrl
BIL Prime Advanced
Bistro Dream S.à r.l.
BJT S.à r.l.
BRC S.à r.l.
Bull's-Eye Property Lux SA
CB Holding S.A.
Cebtimo SA
ChemCore S.A.
Clairefontaine Finance S.à r.l.
Coreval
Creos Luxembourg S.A.
Criali Investment S.A.
Del Monte Luxembourg SARL
Digital Services Holding XXIII S.à r.l.
Dominium Topco S.à r.l.
European Opticians 2 S.à r.l.
First Geneva SICAV-FIS S.A.
Gohu S.A.
Green Europe Lux s.àr.l.
Hess (Luxembourg) Exploration and Production Holding S.à r.l.
La Boqueria S.à r.l.
LCB Prop Co. C S.à r.l.
LF Hotels Acquisition S.à r.l.
LPFE Soparfi A S.à r.l.
Main Tower Development S.à r.l.
Manuel Machado S.à r.l.
Mathey Mazout S.à r.l.
MCL Prop Co. A S.à r.l.
Meneghetti Groupe S.A.
MGE Remscheid SiteCo S.à r.l.
Mobile Challenger Intermediate Group S.A.
Mohican S.A.
Mosqueteiros S.A.
MSEOF Pascal Lux S.à r.l.
Mudra Capital S.A.
Murus Location S.A.
NF Lux Buildings S.A.
Norama Fund
NTT Cable Europe S.A.
O.E.M. SA
Osborne & Moore S.A.
OZ Carbon Trading (Lux) S. à r.l.
Oz Holding S.à.r.l.
Partinvest S.A.
Perunna S.A.
PTL Holdings Luxembourg Sàrl
Radar S.à r.l.
Regie.lu
Rhino HoldCo S.à r.l.
Welcome S.à r.l.
WMC Securitisation S.A.
WP Roaming I S.à r.l.