This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2522
18 septembre 2014
SOMMAIRE
2M Toitures Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121018
Act of Prod S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121015
Altor II S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121015
Altrotech S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121011
Attika S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121010
BCL Fixed Income S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
121014
BM Fund Company . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121056
Bregal-Birchill Investments S.à r.l. . . . . . . .
121020
Bregal Sagemount Investments (Luxem-
bourg) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121014
Chamelon Topco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
121043
CLSec 1 Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121051
Club Odemba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121023
Codic Development . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121013
Compass International Holdings S.à r.l. . .
121041
Compass Printing S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
121037
Digital Services XXVIII (GP) S.à r.l. . . . . .
121026
Dream Global Advisors Luxembourg S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121013
Eco-Finproject S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121019
Edmund Frette S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121019
Eterlux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121018
Eufina S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121019
FL Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121012
Gaïa International Financial Investment
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121011
Hamburg International S.A. . . . . . . . . . . . . .
121016
Hampton Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . .
121024
H.I.G. Luxembourg Holdings Twenty-Two
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121015
Industrial Re S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121016
Inmet Panama II S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121017
JER Adriana S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121011
Logistis Luxembourg Feeder S.A. . . . . . . .
121020
Malasi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121021
Management Marketing IT & Trading S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121010
Matrix EPH 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121010
Matrix German Portfolio One Kaiserslau-
tern S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121010
Mawa S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121013
MD Engineering S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
121056
Meigerhorn Etoy Holding S.à r.l. . . . . . . . . .
121012
Meigerhorn II Morges S. à r.l. . . . . . . . . . . .
121014
Meigerhorn Nation S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
121016
Meigerhorn Rosemont Holding S.à r.l. . . .
121016
Metinvest Development S.à r.l. . . . . . . . . . .
121022
Milleland Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121021
Minacom S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121012
Mitoma S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121021
Mokas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121023
Mondi International . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121012
Mondi Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121014
Monroe CA BC Investment II Sàrl . . . . . . .
121017
Monroe CA BC Investment SARL . . . . . . .
121017
Monterey Investments S.A. . . . . . . . . . . . . .
121023
Morgan Stanley Luxembourg Financing II S
à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121023
Morgan Stanley Luxembourg Financing I S
à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121013
MSREF VI Spirit S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
121022
Neried Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121023
NGS Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121018
Nkozi Consulting S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
121017
Round Point S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121055
SCI Immo de Frisange . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121020
Swedish District Heating 1 S.à r.l. . . . . . . .
121021
Tomkins Holdings Luxembourg S.à r.l. . . .
121022
121009
L
U X E M B O U R G
MMIT SA, Management Marketing IT & Trading S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 675, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 177.418.
Le bilan et l'annexe légale de l'exercice au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014101336/10.
(140120474) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.
Matrix EPH 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 123.530.
Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juillet 2014.
Matrix EPH 2 S.à r.l.
Référence de publication: 2014101340/12.
(140121237) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.
Matrix German Portfolio One Kaiserslautern S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 112.078.
Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juillet 2014.
Matrix German Portfolio One Kaiserslautern S.à r.l.
Référence de publication: 2014101341/12.
(140121235) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.
Attika S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 143.240.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue en date du 2 juin 2014:i>
«Le mandat des administrateurs et commissaire étant échus, l'Assemblée décide de nommer:
- aux fonctions d'Administrateur et de Président du Conseil d'Administration, Monsieur Jeannot DIDERRICH, Expert-
comptable, demeurant professionnellement au 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg;
- à la fonction d'Administrateur, Monsieur Roland DE CILLIA, Expert-comptable, demeurant professionnellement au
45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg;
- à la fonction d'Administrateur, Monsieur Frédéric NOEL, Avocat, demeurant professionnellement au 1, avenue de
la Gare L-1611 Luxembourg;
- à la fonction de Commissaire aux Comptes, la société BENOY KARTHEISER MANAGEMENT S.à.r.l., inscrite au
Registre de Commerce de Luxembourg n° B 33849, établie aux 45-47 route d'Arlon, L-1140 Luxembourg.
Leur mandat s'achèvera lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2017».
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
ATTIKA S.A.
Référence de publication: 2014103794/20.
(140124716) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2014.
121010
L
U X E M B O U R G
Altrotech S.A., Succursale d'une société de droit étranger.
Adresse de la succursale: L-3895 Foetz, 3, rue des Artisans.
R.C.S. Luxembourg B 49.925.
<i>Rectificatif de l'extrait de procès-verbal déposé au Registre de Commerce le 27/05/2014 sous la référence L140087731.i>
<i>Extrait du Procès-Verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui s'est tenue à Foetz le 21 février 2014i>
Il résulte des résolutions prises le 21 février 2014, lors de l'Assemblée Générale des actionnaires de la société AL-
TROTECH S.A. inscrite au RC sous le numéro B49.925:
1. La révocation du Responsable de la succursale, Monsieur Jean Claude ORSCHEL.
2. La révocation du Gérant technique, Monsieur Pierre LOUVIOT.
3. La nomination de Monsieur Samuel STILLAVATO, employé privé, né le 26/04/1978 à Mont-Saint-Martin (France)
et demeurant 45 Cité Joseph Brebsom, 4046 Esch-Sur-Alzette (Luxembourg) en tant qu'administrateur
Pour extrait conforme,
Foetz, le 21 février 2014.
Référence de publication: 2014103778/17.
(140123910) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2014.
JER Adriana S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 134.613.
Il est à noter que l'associé unique de la Société a décidé comme suit:
- de révoquer de Monsieur Hervé Marsot de son mandat de gérant de la Société avec effet au 15 juillet 2014;
- de nommer Madame Julie Pierre, née le 29 mai 1982 à Epinal, France, demeurant professionnellement au 41 Avenue
de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, en tant que nouvelle gérante de la Société avec effet
au 15 juillet 2014 et pour une durée indéterminée;
Le conseil de gérance de la Société est désormais composé de:
Madame Julie Pierre, gérante.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
JER Adriana S.à r.l.
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2014105021/18.
(140125182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2014.
Gaïa International Financial Investment S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 94.621.
Conformément à l'article 3 (1) de la loi du 31 mal 1999 régissant la domiciliation des sociétés, Fiduciaire Patrick
Sganzerla, Société à responsabilité limitée ayant son siège social au 19, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg et en-
registrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 96.848, informe de la
dénonciation de la convention de domiciliation conclue le 17 mars 2009 avec:
Gaïa International Financial Investment S.A., enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 94.621 et ayant son siège social au 19, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg.
Et ce avec effet au 20 juin 2014.
Luxembourg, le 21 juillet 2014.
Fiduciaire Patrick Sganzerla
Société à responsabilité limitée
<i>L'agent domiciliataire
i>Patrick Sganzerla
<i>Gérant uniquei>
Référence de publication: 2014106661/19.
(140127295) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.
121011
L
U X E M B O U R G
Meigerhorn Etoy Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 138.547.
Le bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014101379/9.
(140120506) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.
Mondi International, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 58.464.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
juillet 2014.
Référence de publication: 2014101349/10.
(140120475) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.
FL Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 151.065.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 11 juin 2014.i>
Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont venus à échéance.
Monsieur Philip FOURNIER, domicilié au 4, rue Hippolyte Maindron, F-49000 Angers, est réélu Administrateur de
catégorie A et les sociétés FMS SERVICES S.A., ayant son siège social au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg et S.G.A.
SERVICES S.A., ayant son siège social au 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg sont réélus Administrateurs de catégorie
B pour une nouvelle période de 1 an.
Monsieur Eric HERREMANS adresse professionnelle au 39, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, est réélu Commissaire
aux Comptes pour une nouvelle période de 1 an.
<i>Pour la société
i>FL FINANCE S.A.
Référence de publication: 2014106648/17.
(140127844) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.
Minacom S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 162.924.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social en date du 19 juin 2014i>
<i>3 i>
<i>èmei>
<i> Résolution:i>
L'Assemblée Générale décide de renouveler, avec effet au 19 juin 2014, le mandat des administrateurs:
- Madame Cornelia METTLEN,
- Monsieur Adrien COULOMBEL, demeurant 3A rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- Monsieur Jean-Pierre VERLAINE, président du Conseil d'Administration demeurant 3A rue Guillaume Kroll, L-1882
Luxembourg
et le mandat du Commissaire aux comptes: H.R.T. Révision S.A.
jusqu'à l'assemblée générale statutaire à tenir en 2015.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société MINACOM S.A.i>
Référence de publication: 2014101396/18.
(140120409) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.
121012
L
U X E M B O U R G
Mawa S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R.C.S. Luxembourg B 186.114.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juillet 2014.
Référence de publication: 2014101342/10.
(140120067) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.
Morgan Stanley Luxembourg Financing I S à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 148.169.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juillet 2014.
<i>Pour la société Morgan Stanley Luxembourg Financing I S.à r.l.i>
Référence de publication: 2014101355/11.
(140120613) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.
Dream Global Advisors Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2920 Luxembourg, 9A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 160.395.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions écrites adoptés par les gérants de la Société en date du 14 juillet 2014 que Monsieur Cengiz
Coelhan a été révoqué de sa fonction de délégué à la gestion journalière de la Société avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
Dream Global Advisors Luxembourg S.à r.l.
Référence de publication: 2014103033/13.
(140121595) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2014.
Codic Development, Société Anonyme.
Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.
R.C.S. Luxembourg B 78.676.
EXTRAIT
Il résulte d'une lettre de démission datée du 7 juillet 2014 actée par le conseil d'administration de la Société lors de
la réunion tenue en date du 8 juillet 2014 que Monsieur Raffaele Guiducci a démissionné de sa fonction d'administrateur
de la Société avec effet au 8 juillet 2014.
Il résulte des décisions prises lors de cette même réunion du conseil d'administration de la Société du 8 juillet 2014
que Monsieur Philippe Weicker, né le 5 avril 1958 à Schaerbeek, Belgique, résidant au 33 Avenue Champel, 1640 Rhode-
Saint-Genèse, Belgique, a été coopté en qualité de nouvel administrateur de la Société en remplacement de l'administra-
teur démissionnaire, et ce avec effet au 8 juillet 2014 et jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires qui se
prononcera sur son élection définitive.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 14 juillet 2014.
<i>Pour la Société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2014102994/20.
(140121868) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2014.
121013
L
U X E M B O U R G
Meigerhorn II Morges S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 139.571.
Le bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014101380/9.
(140120507) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.
Mondi Services, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 58.463.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
juillet 2014.
Référence de publication: 2014101350/10.
(140120577) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.
BCL Fixed Income S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 101.600,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 9, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 164.137.
Les comptes annuels au 20 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 20 juin 2014.
Certifié conforme et sincère
<i>Pour la Société
i>Manfred Zisselberger
<i>Géranti>
Référence de publication: 2014102880/14.
(140121861) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2014.
Bregal Sagemount Investments (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R.C.S. Luxembourg B 170.584.
EXTRAIT
Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société qui s'est tenue en date du 20 juin 2014 au siège social que:
Suite à la réélection de tous les gérants sortants, leurs mandats se terminant lors de l'Assemblée statuant sur les
comptes de l'exercice 2014, le Conseil de Gérance se compose de:
- Raf BOGAERTS, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à 48 rue de Bragance, L-1255 Luxembourg;
- John DRURY, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à Michelin House, 3
ème
étage, 81, Fulham
Road, Londres SW3 6RD, Angleterre;
- Robert SMEELE, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à Grafenauweg, 10, CH-6300 Zug, Suisse;
- Johny SERÉ, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à Jean Monnetlaan, B-1804 Vilvoorde, Belgique;
- Dimitri MARECHAL, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à 48 rue de Bragance, L-1255 Luxem-
bourg;
- Peggy PARTIGIANONE, administratrice de sociétés, avec adresse professionnelle à 48 rue de Bragance, L-1255
Luxembourg.
Référence de publication: 2014102905/21.
(140121757) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2014.
121014
L
U X E M B O U R G
Act of Prod S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5720 Aspelt, 1, Um Klaeppchen.
R.C.S. Luxembourg B 165.476.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16/07/2014.
G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg
Référence de publication: 2014103764/12.
(140123982) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2014.
H.I.G. Luxembourg Holdings Twenty-Two S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 161.574.
Par résolutions signées en date du 3 juin 2014, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Acceptation de la démission de Mark Bonham, avec adresse au 25, St George Street, W1S1FS Londres, Royaume-
Uni, de son mandat de gérant A, avec effet au 3 juin 2014;
2. Nomination de Daphné Chanteloup, avec adresse professionnelle au 9A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg,
au mandat de gérant A, avec effet au 3 juin 2014 et pour une durée indéterminée;
3. Nomination de Peter Griffiths, avec adresse professionnelle au 25, St George Street, W1S1FS Londres, Royaume-
Uni, au mandat de gérant A, avec effet au 3 juin 2014 et pour une durée indéterminée;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 juillet 2014.
Référence de publication: 2014105781/17.
(140126575) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2014.
Altor II S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 35.950,00.
Siège social: L-1748 Luxembourg, 7, rue Lou Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 115.997.
<i>Extrait des résolutions de l'actionnaire unique de la société Altor II S.à r.l (la «société») du 1 i>
<i>eri>
<i> juillet 2014i>
1. Acceptation de la résignation de Monsieur Claes-Johan Gustaf Geijer, né le 15 juin 1957 à Hedvig Eleonora, Stock-
holm, Suède, résidant au 31 Rue Franz Clement, L-1345 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que gérant
de la Société avec effet le 30 juin 2014.
2. Acceptation de la résignation de Madame Anke Jager, née le 22 avril 1968 à Salzgitter, Allemagne, résidant profes-
sionnellement au 7, rue Lou Hemmer, Luxembourg-Findel, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que gérante de la
Société avec effet le 30 juin 2014.
3. Acceptation de la nomination de Madame Hanna Duer, née le 7 mai 1966 à Gentofte, Danemark, résidant au 99
Rue Centrale, L-4499 Limpach, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que gérante de la Société avec effet le 1
er
juillet
2014.
4. Acceptation de la nomination de Mademoiselle Dalia Ziukaite, née le 17 juin 1983 à Alytus, Lituanie, résidant pro-
fessionnellement au 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Findel, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que gérante de la Société
avec effet le 1
er
juillet 2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
juillet 2014.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2014103777/25.
(140124296) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2014.
121015
L
U X E M B O U R G
Meigerhorn Nation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 138.129.
Le bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014101381/9.
(140120509) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.
Meigerhorn Rosemont Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 137.521.
Le bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014101382/9.
(140120508) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.
Industrial Re S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 36.702.
<i>Extrait des résolutions de l'assemblée générale du 26 juin 2014i>
L'Assemblée renouvelle les mandats de ITSEMAP, Servicios Tecnologicos Mapfre, s.a., représentée par Mr. Alfredo
ARAN IGLESIA, de SERVIFINANZAS S.A., représentée par Mr. José Maria del POZO JODRA, de MAPFRE GLOBAL
RISKS, Compañia Internacional de Seguros y Reaseguros s.a., représentée par Mr Tony ROSENTHAL et de Risk &
Reinsurance Solutions SA en abrégé 2RS représentée par Mr Arnaud Bierry, jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale
Ordinaire 2017 qui statuera sur les comptes de l'exercice 2016.
L'assemblée reconduit le mandat du réviseur d'entreprises Ernst & Young, 7 rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach,
jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire 2015 qui statuera sur les comptes de l'exercice 2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
Référence de publication: 2014106759/17.
(140128089) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.
Hamburg International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 90.393.
<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration tenue en date du 30 mai 2014i>
Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 30 mai 2014 que:
- Le siège social de la société est transféré du 42-44 avenue de la gare L-1610 Luxembourg au 50, rue Charles Martel,
L-2134 Luxembourg, avec effet au 1
er
juin 2014.
- Les administrateurs M. Claude ZIMMER, M. Hendrik H.J. (Rob) KEMMERLING et M. Rob SONNENSCHEIN sont
domiciliés professionnellement au 50, rue Charles Martel 1
er
étage, L-2134 Luxembourg et ce, avec effet au 1
er
juin
2014.
- L'administrateur LuxGlobal Management S.à r.l, société enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
Luxembourg sous le numéro B159.893 est transféré au 50, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg et ce, avec effet au
1
er
juin 2014. Représentant permanent M. Hendrik H.J. KEMMERLING domicilié professionnellement au 50, rue Charles
Martel, 1
er
étage L-2134 Luxembourg et ce, avec effet au 1
er
juin 2014.
Extrait sincère et conforme
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2014105787/19.
(140126089) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2014.
121016
L
U X E M B O U R G
Monroe CA BC Investment II Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 174.182.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2014101351/10.
(140121279) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.
Monroe CA BC Investment SARL, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 174.181.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2014101352/10.
(140121280) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.
Nkozi Consulting S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
R.C.S. Luxembourg B 109.616.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
«Par jugement rendu en date du 3 juillet 2014, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,
siégeant en matière commerciale, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société à
responsabilité limitée NKOZI CONSULTING S.àr.l., dont le siège social à L-1611 Luxembourg, 61 avenue de la Gare, a
été dénoncé en date du 12 novembre 2008.
Pour extrait conforme
Maître Ersan ÖZDEK
<i>Le liquidateur / Avocati>
Référence de publication: 2014103721/14.
(140123558) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2014.
Inmet Panama II S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 168.868.
EXTRAIT
Il résulte des décisions prises par l'actionnaire unique en date du 25 avril 2014 que le mandat des administrateurs de
la Société a été renouvelé et ce, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2020:
- Madame Karen TYLER;
- Monsieur Emmanuel REVEILLAUD;
- Monsieur Fredy THYES;
- Monsieur Philippe SALPETIER.
Il résulte des décisions prises par l'actionnaire unique en date du 25 avril 2014 que le mandat du Réviseur d'Entreprises
Agréé, la société PricewaterhouseCoopers a été renouvelé et ce, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra
en 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 21 juillet 2014.
Référence de publication: 2014106767/20.
(140127787) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.
121017
L
U X E M B O U R G
Eterlux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1147 Luxembourg, 42, rue de l'Avenir.
R.C.S. Luxembourg B 29.029.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 7 mai 2014i>
(...)
«Le mandat de commissaire de Monsieur Dirk Jacobs vient à échéance à l'issue de la présente assemblée. L'assemblée
décide de renouveler leur mandat pour une durée de trois ans, prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de
2017, statuant sur les comptes de l'exercice 2016.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.»
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 7 mai 2014.
Karin DUBOIS
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2014104864/17.
(140125759) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2014.
2M Toitures Sàrl, Succursale d'une société de droit étranger.
Adresse de la succursale: L-9964 Huldange, 49, Duarrefstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 178.726.
FERMETURE D'UNE SUCCURSALE
Je soussigne Mickael Malmonte, Directeur général de la société 2M Toitures LTD immatriculée à 145-157 St John
Street EC1V 4PW London, ENGLAND (Limited Company "société à responsabilité limitée" enregistrée au registre
Companies House au N°: 08615161) souhaite fermer la succursale 2M Toitures SARL à Duarrefstrooss 49 L-9964 Hul-
dange immatriculée au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B178726.
Cette succursale arrêtera son activité le 14/07/2014.
Le représentant de la succursale au Grand Duché de Luxembourg est Monsieur Mickael Malmonte, Directeur général
de la société 2M Toitures LTD résidant au 15 rue du Fanum F-57185 Vitry sur Orne. Il a le pouvoir de signature de façon
indépendante ainsi que tous les pouvoirs au sein de la succursale Luxembourgeoise.
Mickael Malmonte
<i>Directeur Générali>
Référence de publication: 2014103655/18.
(140121142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2014.
NGS Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 136.258.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le lundi 30 juin 2014i>
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue en date du 30 juin 2014 que:
L'Assemblée a accepté la démission de Madame Madeleine THOMASSET de ses fonctions d'administrateur et décide
de nommer en son remplacement la personne suivante:
- Monsieur Olivier LECLIPTEUR, né le 17 janvier 1969 à Rocourt (B), demeurant professionnellement à L-1258 Lu-
xembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
Le nouvel administrateur termine le mandat de son prédécesseur qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale
annuelle statuant sur l'exercice clôturé le 31 décembre 2017.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Pour extrait conforme
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2014101419/19.
(140121047) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.
121018
L
U X E M B O U R G
Eco-Finproject S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R.C.S. Luxembourg B 90.298.
Par décisions de l'Assemblée Générale et du Conseil d'Administration en date du 30 juin 2014 ont été nommés, jusqu'à
l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels clôturant au 31 décembre 2016:
- Luc BRAUN, 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Administrateur, Administrateur-Délégué et Président;
- Jean-Marie POOS, 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Administrateur et Administrateur-Délégué;
- Giuseppe FRANCHI, 14 Via Monte Grappa I - 20024 Garbagnate Milanese Administrateur;
- EURAUDIT Sàrl, 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Commissaire.
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2014104842/15.
(140125043) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2014.
Edmund Frette S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 82.710.000,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 119.472.
<i>Rectificatif du dépôt N° L140123613 enregistré le 16 juillet 2014i>
Une erreur matérielle s'est produite lors du dépôt enregistré en date du 16 juillet 2014 sous la référence L140123613.
En effet, le nom du nouveau gérant A doit se lire comme suit: Monsieur Nico IACUZZI.
Toutes les autres dispositions de la publication restent inchangées.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juillet 2014.
EDMUND FRETTE S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2014104844/16.
(140125946) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2014.
Eufina S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 4, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 68.478.
EXTRAIT
La Société a été informée du décès de l'un de ses administrateurs, à savoir feu Monsieur Antoine de SCHORLEMER,
survenu en date du 27 février 2014, de sorte que son mandat d'administrateur a pris fin de plein droit avec effet à la même
date.
Suite à la démission en date du 30 juin 2014 de ses fonctions d'administrateur de Monsieur Jean-Jacques de LAUNOIT,
le conseil d'administration, lors de sa réunion du 17 juillet 2014, a coopté Madame Nathalie GAUTIER qui terminera le
mandat de son prédécesseur:
- Madame Nathalie GAUTIER, Master Administration des Entreprises, demeurant professionnellement au 6, rue Adol-
phe, L-1116 Luxembourg, aux fonctions d'Administrateur.
Son mandat prendra fin en même temps que tous les autres mandats, lors de l'assemblée générale ordinaire statuant
sur les comptes au 31 décembre 2015.
En outre, le conseil d'administration, lors de sa réunion du 17 juillet 2014, a nommé Monsieur Jacques MOULAERT,
aux fonctions de Président du conseil d'administration.
Luxembourg, le 17 juillet 2014.
<i>Pour EUFINA S.A.
i>Société anonyme
Référence de publication: 2014104865/23.
(140125309) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2014.
121019
L
U X E M B O U R G
Logistis Luxembourg Feeder S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 140.269.
<i>Extrait des résolutions prises par l'actionnaire unique le 10 juillet 2014i>
En date du 10 juillet 2014, l'Actionnaire unique de la Société, a décidé ce qui suit:
- de nommer AEW EUROPE S.àr.l et Monsieur Frédéric BARZIN en qualité d'administrateur de la Société jusqu'à la
prochaine Assemblée Générale Annuelle de l'Actionnaire approuvant les comptes annuels qui se tiendra en 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ainsi fait à Luxembourg, le 11 juillet 2014.
Référence de publication: 2014101320/13.
(140120449) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.
SCI Immo de Frisange, Société Civile Immobilière.
Capital social: EUR 1.000,00.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 117, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg E 4.843.
<i>Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire du 8 juillet 2014i>
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des associés, tenue ordinairement en date du 8 juillet
2014:
L'assemblée décide de nommer en remplacement de Monsieur Sébastien THIBAL démissionnaire, au poste de Gérant
pour une durée indéterminée:
- Monsieur Didier, Gilbert, Marie LORRAIN, né le 9 juillet 1954 à Metz (France), demeurant professionnellement au
296-298 route de Longwy L-1940 Luxembourg.
<i>Le Mandatairei>
Référence de publication: 2014103529/15.
(140122243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2014.
Bregal-Birchill Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 60.000.000,00.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R.C.S. Luxembourg B 57.794.
EXTRAIT
Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société qui s'est tenue en date du 20 juin 2014 au siège social que:
Suite à la réélection de tous les gérants sortants, leurs mandats se terminant lors de l'Assemblée statuant sur les
comptes de l'exercice 2014, le Conseil de Gérance se compose de:
- Raf BOGAERTS, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à 48 rue de Bragance, L-1255 Luxembourg;
- John DRURY, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à Michelin House, 3
ème
étage, 81, Fulham
Road, Londres SW3 6RD, Angleterre;
- Robert SMEELE, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à Grafenauweg, 10, CH-6300 Zug, Suisse;
- Johny SERÉ, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à Jean Monnetlaan, B-1804 Vilvoorde, Belgique;
- Wolter BRENNINKMEIJER, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à Michelin House, 3
ème
étage,
81, Fulham Road, Londres SW3 6RD, Angleterre;
- Dimitri MARECHAL, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à 48 rue de Bragance, L-1255 Luxem-
bourg;
- Peggy PARTIGIANONE, administratrice de sociétés, avec adresse professionnelle à 48 rue de Bragance, L-1255
Luxembourg.
A été réélu comme réviseur d'entreprises agréé, son mandat prenant fin lors de l'Assemblée qui se prononcera sur
les comptes de l'exercice 2014:
- Ernst & Young, ayant son siège social à L-5365 Munsbach, 7 rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2.
Référence de publication: 2014102906/26.
(140121799) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2014.
121020
L
U X E M B O U R G
Milleland Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 91.568.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014101393/9.
(140120976) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.
Mitoma S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 68.023.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014101398/9.
(140120933) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.
Malasi S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 81.143.
Le soussigné a dénoncé au 1
er
juillet 2014 la domiciliation du siège, situé au 70, Grand-Rue, L-1660, de la société
MALASI S.A., inscrite au Registre de Commerce et des Société sous le numéro B 81143.
Le 14 juillet 2014.
Erwin SOTIRI
<i>Le domiciliatairei>
Référence de publication: 2014101364/11.
(140121276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.
Swedish District Heating 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 11.432.680,00.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 185.346.
EXTRAIT
Par contrat de cession de parts sociales du 10 juillet 2014, l'associé de la Société, HgCapital Renewables (Nominees)
Limited, a transféré les parts sociales qu'il détenait dans la Société de la manière suivante:
- 1,143,268 parts sociales ordinaires de catégorie A
- 1,143,268 parts sociales ordinaires de catégorie B
- 1,143,268 parts sociales ordinaires de catégorie C
- 1,143,268 parts sociales ordinaires de catégorie D
- 1,143,268 parts sociales ordinaires de catégorie E
- 1,143,268 parts sociales ordinaires de catégorie F
- 1,143,268 parts sociales ordinaires de catégorie G
- 1,143,268 parts sociales ordinaires de catégorie H
- 1,143,268 parts sociales ordinaires de catégorie I
- 1,143,268 parts sociales ordinaires de catégorie J
à HgCapital RPP2 Nominees Limited, une société ayant son siège social au 2, More London Riverside, SE1 2AP Londres,
Royaume-Uni et immatriculée sous le numéro 9092946.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Référence de publication: 2014104444/25.
(140124062) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2014.
121021
L
U X E M B O U R G
Tomkins Holdings Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 103.000,00.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 23-25, rue Notre-Dame.
R.C.S. Luxembourg B 102.555.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2013 de la Société, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rap-
portent, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 9 juillet 2014.
Pour extrait conforme
ATOZ
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Signature
Référence de publication: 2014103568/17.
(140122464) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2014.
Metinvest Development S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 156.242.
<i>Extrait des résolutions circulairesi>
Il résulte du Conseil de gérance par voie circulaire que:
- le siège social de la société est transféré du 42-44 avenue de la gare L-1610 Luxembourg au 50, rue Charles Martel,
L-2134 Luxembourg, avec effet au 1
er
juin 2014.
- Le gérant M. Claude ZIMMER, est domicilié professionnellement au 50, rue Charles Martel 1
er
étage, L-2134 Lu-
xembourg et ce, avec effet au 1
er
juin 2014.
- Le gérant Luxglobal Management S.à r.l, société enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés Lu-
xembourg sous le numéro B159.893 est transféré au 50, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg et ce, avec effet au 1
er
juin 2014.
Extrait sincère et conforme
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2014104282/18.
(140124449) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2014.
MSREF VI Spirit S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 128.450.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique du 19 juin 2014i>
L'associé unique de MSREF VI Spirit Sarl (la "Société") a décidé comme suit:
- d'accepter la démission de Jan-Dries Mulder en tant que gérant de catégorie B et la démission de Stefan Koch en
tant que gérant de catégorie B;
et
- de nommer gérant de catégorie B suivant avec effet au 19 juin 2014 et pour une durée indéterminée:
* Susanne Muntinga-van den Houten, née le 07 août 1979 a S-Hertogenbosch, Pays-Bas, demeurant professionnelle-
ment au Kabelweg 37, 1014 BA Amsterdam, Pays-Bas
et
* Sharon Callahan, née le 19 octobre 1966 à New-York, États-Unis, demeurant professionnellement au 20 Rue de la
Poste, L-2346 Luxembourg
Luxembourg, le 04 Juillet 2014.
Référence de publication: 2014104289/19.
(140124894) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2014.
121022
L
U X E M B O U R G
Monterey Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 71.082.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014101401/9.
(140121187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.
Morgan Stanley Luxembourg Financing II S à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 148.167.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juillet 2014.
<i>Pour la société Morgan Stanley Luxembourg Financing II S.à r.l.i>
Référence de publication: 2014101356/11.
(140120677) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.
Mokas, Société Anonyme,
(anc. Club Odemba).
Siège social: L-1660 Luxembourg, 4, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 167.411.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juillet 2014.
Paul DECKER
<i>Le Notairei>
Référence de publication: 2014101348/12.
(140120510) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.
Neried Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 29.328.
- Constituée suivant acte reçu par Maître Reginald NEUMAN, notaire alors de résidence à L -LUXEMBOURG, en date
du 18 novembre 1988, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n° 41 du 15 février 1989;
- Statuts modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois en date du 30 janvier 2003 suivant acte reçu par Maître
Jean-Paul HENCKS, notaire de résidence à L - LUXEMBOURG, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n°263 du 12
mars 2003.
Il résulte du procès verbal de l'assemblée générale tenue au siège social de la société le 6 juin 2014 que les décisions
suivantes ont été prises à l'unanimité des voix:
- démission de Madame Consuelo MORET CATALA de sa fonction d'administrateur avec effet immédiat.
- Nomination des administrateurs suivants jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2018:
* Madame Maria Desamparados GIL MORET, demeurant à E-46004 VALENCE, Calle Colón n° 7, 3
ème
étage, Porte
8,
* Monsieur José Jaime GIL MORET, demeurant à E-46004 VALENCE, Calle Colón n° 7, 2
ème
étage, Porte 5.
Luxembourg, le 8 juillet 2014.
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Référence de publication: 2014104298/22.
(140124498) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2014.
121023
L
U X E M B O U R G
Hampton Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 31-33, rue Sainte Zithe.
R.C.S. Luxembourg B 156.378.
In the year two thousand and fourteen, on the fifteen of July.
Before Us, Maître Blanche MOUTRIER, notary residing in Esch-sur-Alzette (Grand-Duchy of Luxembourg).
THERE APPEARED:
Hampton Investments Ltd., an exempted company limited by shares incorporated in the Cayman Islands with limited
liability, having its registered office at PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104 Cayman Islands, registered
with the Registrar of Companies of the Cayman Islands under number MC-245767,
here represented by Mr. Charles ALTWIES, acting in his capacity as Managing Director of the company G.T. Fiduciaires
S.A., a public company limited by shares (société anonyme), having its registered office at L-1273 Luxembourg, 19, rue
de Bitbourg, registered with the Luxembourg register of commerce and companies under the number B 121.820.
by virtue of a proxy given under private seal.
Such proxy, after been signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary will
remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as aforementioned, requested the undersigned notary to record the following:
I. The appearing party is the sole shareholder of the company Hampton Luxembourg S.à r.l., a private limited liability
company (société à responsabilité limitée) organized under the laws of Luxembourg, having its registered office at L-2763
Luxembourg, 31-33 rue Ste Zithe, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies (“Registre de
Commerce et des Sociétés”), under the number B 156378, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary,
on 29 October 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2673 of 6 December
2010 (the “Company”). The articles of incorporation of the Company have been amended pursuant to a deed of Maître
Léonie GRETHEN, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, on 3 November 2010, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2813 of 22 December 2010 (the “Articles of Incorporation”).
II. The corporate capital is set at USD 12,346,300.- (twelve million three hundred forty-six thousand three hundred
US dollars) represented by 123,463 (one hundred twenty-three thousand four hundred sixty-three) shares with a nominal
value of USD 100.-(one hundred US dollars) each, all subscribed and fully paid up, whereby it is precised that there are
no separate classes of shares.
III. The agenda is worded as follows:
“1. Liquidation of the Company;
2. Appointment of a liquidator;
3. Determination of the powers of said liquidator;
4. Determination of the remuneration of said liquidator.”
IV. Pursuant to article 17 of the Articles of Incorporation, at the time of winding up the Company the liquidation will
be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine
their powers and remuneration.
V. Pursuant to article 13 of the Articles of Incorporation, the sole shareholder assumes all powers conferred to the
general shareholders' meeting.
VI. The appearing party, duly represented, then passes the following resolutions:
<i>First resolution:i>
The sole shareholder resolves to dissolve the Company and to put it into liquidation as of the present date.
<i>Second resolution:i>
The sole shareholder resolves to appoint the company G.T. Fiduciaires S.A., a public company limited by shares (société
anonyme), having its registered office at L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, registered with the Luxembourg register
of commerce and companies under the number B 121.820, as liquidator.
<i>Third resolution:i>
The sole shareholder resolves to confer to the liquidator the broadest powers set forth in articles 144 and seq. of the
Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the “Law”).
The liquidator shall be entitled to pass all deeds and carry out all operations in the name of the Company, including
those referred to in article 145 of the Law, without the prior authorization of the sole shareholder.
The liquidator is exempted from the obligation of drawing up an inventory, and may in this respect fully rely on the
books of the Company.
121024
L
U X E M B O U R G
The liquidator may, under its own responsibility, delegate its powers for specific and defined operations or tasks to
one or several persons or entities.
The liquidator shall also be empowered and authorized to make, at its sole discretion, advance payments in cash or in
kind of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the sole shareholder, in accordance with article 148 of the Law.
<i>Fourth resolution:i>
The sole shareholder resolves that the liquidator shall be remunerated according to the standard practice.
<i>Expenses:i>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this
document, are estimated at approximately EUR 1,100.-.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Esch/Alzette, on the day named at the beginning.
The deed having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with Us, the
notary, the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille quatorze, le quinze juillet.
Par-devant Nous, Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg).
A COMPARU:
Hampton Investments Ltd., une société exonérée limitée par actions des Iles Caïmanes et à responsabilité limitée,
ayant son siège social à PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104 Iles Caïmanes, immatriculée auprès du
Registre de Commerce des Iles Caïmanes sous le numéro MC-245767,
ici représentée par Monsieur Charles ALTWIES, agissant en sa qualité d'administrateur-délégué de la société G.T.
Fiduciaires S.A., une société anonyme, établie et ayant son siège social à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, enre-
gistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 121.820.
en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
Laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de la comparante et par le notaire sous-
signé, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
La comparante, représentée comme susmentionné, a requis le notaire soussigné d'acter ce qui suit:
I. La comparante est l'associée unique de la société Hampton Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée,
organisée sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à L-2673 Luxembourg, 31-33 rue Ste
Zithe, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 156378, constituée
suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 29 octobre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 2673 du 6 décembre 2010 (la «Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés suivant acte
reçu par Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 3
novembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2813 du 22 décembre 2010 (les
«Statuts»).
II. Le capital social est fixé à USD 12.346.300.- (douze millions trois cent quarante-six mille trois cents dollars améri-
cains), représenté par 123.463 (cent vingt-trois mille quatre cent soixante-trois) parts sociales d'une valeur nominale de
USD 100.-(cent dollars américains) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées, étant précisé qu'il n'y a pas diffé-
rentes classes de parts sociales.
III. L'ordre du jour est rédigé comme suit:
«1. Mise en liquidation de la Société
2. Nomination d'un liquidateur
3. Détermination des pouvoirs du liquidateur
4. Fixation de la rémunération du liquidateur.»
IV. Suivant l'article 17 des Statuts, au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou
plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
V. Suivant l'article 13 des Statuts, L'associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés.
VI. La comparante, dûment représentée, prend ensuite les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'associée unique décide la dissolution de la Société et sa mise en liquidation à compter de ce jour.
121025
L
U X E M B O U R G
<i>Deuxième résolutioni>
L'associée unique décide de nommer comme liquidateur la société G.T. Fiduciaires S.A., une société anonyme, établie
et ayant son siège social à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, enregistrée au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 121.820.
<i>Troisième résolutioni>
L'associée unique décide de conférer au liquidateur les pouvoirs les plus étendus tels que prévus aux articles 144 et
suivants de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la ‘'Loi'').
Le liquidateur sera autorisé à passer tous les actes et effectuer toutes les opérations au nom de la Société, y compris
les actes et opérations prévus à l'article 145 de la Loi, sans autorisation préalable de l'associée unique.
Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut entièrement s'en référer aux écritures de la Société.
Le liquidateur pourra déléguer, sous sa propre responsabilité, ses pouvoirs pour des opérations ou tâches spécifiques
et définies à une ou plusieurs personnes physiques ou morales.
Le Liquidateur sera autorisé, à sa seule discrétion, à verser des avances en numéraire ou en nature sur le boni de
liquidation à l'associée unique de la Société, conformément à l'article 148 de la Loi.
<i>Quatrième résolutioni>
L'associé unique décide que le liquidateur sera rémunéré conformément aux usages de la place.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques, qui incombent à la Société des suites de ce document, sont
estimés à approximativement EUR 1.100.-.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande de la comparante, le présent
acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction française. A la requête de la même comparante et en cas de
divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous, notaire, le
présent acte.
Signé: ALTWIES, MOUTRIER.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 16/07/2014. Relation: EAC/2014/9834. Reçu douze euros 12,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): HALSDORF.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.
Esch-sur-Alzette, le 17 juillet 2014.
Référence de publication: 2014104072/138.
(140124863) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2014.
Digital Services XXVIII (GP) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 188.565.
STATUTES
In the year two thousand and fourteen, on the eighteenth day of June.
Before us Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Digital Services XXVIII S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of Grand
Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg,
the registration of which with the Luxembourg Trade and Companies’ Register is pending,
here represented by Mr. Luis AGUERRE ENRÍQUEZ, Doctor en Derecho, residing in Luxembourg,, by virtue of a
proxy, given in Berlin, Germany, on 18. June 2014, and in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 18. June 2014.
Said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to
this deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party has requested the officiating notary to enact the deed of incorporation of a private limited
company (société à responsabilité limitée) which it wishes to incorporate with the following articles of association:
121026
L
U X E M B O U R G
A. Name - Purpose - Duration - Registered office
Art. 1. Name - Legal Form. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name
Digital Services XXVIII (GP) S.à r.l. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915
concerning commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.
Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign
companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio in view of its realisation by sale, exchange or otherwise.
2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it
holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the
Company.
2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by
issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.
2.4 The Company may also act as a partner with unlimited or limited liability for the debts and obligations of any
Luxembourg or foreign entity.
2.5 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities
which it considers useful for the accomplishment of these purposes.
Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of
managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution
of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution
of the board of managers.
4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances
or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
traordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwiths-
tanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.
B. Share capital - Shares
Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), represented by twelve
thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.
5.2 The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
5.3 The Company may redeem its own shares.
Art. 6. Shares.
6.1 The Company’s share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of
the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.
Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection
by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.
7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall
appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.
121027
L
U X E M B O U R G
7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given
by the shareholders at a majority of three quarters of the share capital.
7.5 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of
the transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.
7.6 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject
to the approval of such transfer given by the surviving shareholders at a majority of three quarters of the share capital.
Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving
spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.
C. Decisions of the shareholders
Art. 8. Collective decisions of the shareholders.
8.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles
of association.
8.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
8.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise
conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case,
each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his
vote in writing.
8.4 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of
shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by
the sole shareholder.
Art. 9. General meetings of shareholders. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, at least
one general meeting of shareholders shall be held within six (6) months of the end of each financial year in Luxembourg
at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the convening notice of such meeting.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices
of meeting. If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived
any convening requirement, the meeting may be held without prior notice or publication.
Art. 10. Quorum and vote.
10.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
10.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company’s
shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share
capital. If this majority is not reached in a first meeting or proposed written resolution, the shareholders may be convened
a second time with the same agenda or receive such proposed written resolution a second time by registered letter,
decisions are validly adopted in so far as they are adopted by a majority of the votes validly cast whichever is the fraction
of the share capital represented.
Art. 11. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.
Art. 12. Amendments of the articles of association. Any amendment of the articles of association requires the approval
of (i) a majority of shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.
D. Management
Art. 13. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
13.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers
form a board of managers.
13.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not
expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of
association is to be construed as a reference to the “sole manager”.
13.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any
actions necessary or useful to fulfil the Company’s corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the
Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.
Art. 14. Appointment, removal and term of office of managers.
14.1 The manager(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remune-
ration and term of office.
14.2 The managers shall be appointed and may be removed from office at any time, with or without cause, by a decision
of the shareholders representing more than half of the Company’s share capital.
121028
L
U X E M B O U R G
14.3 The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two (2) different classes, being class A
managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant
shareholders resolutions and the managers be identified with respect to the class they belong.
Art. 15. Vacancy in the office of a manager.
15.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or
otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the replaced manager by the remaining managers until the next meeting of shareholders which shall resolve on the
permanent appointment, in compliance with the applicable legal provisions.
15.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company’s sole manager, such vacancy must be filled without undue
delay by the general meeting of shareholders.
Art. 16. Convening meetings of the board of managers.
16.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held
at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.
16.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four (24) hours at
least in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document
being sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location
determined in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.
16.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive
any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of
managers.
Art. 17. Conduct of meetings of the board of managers.
17.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not
need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
17.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers.
In his absence, the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority
of managers present or represented at any such meeting.
17.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either
in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.
17.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other
means of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis
and allowing an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a
participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.
17.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or
represented at a meeting of the board of managers.
17.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,
if any, shall not have a casting vote. In the event where the general meeting of shareholders has appointed different classes
of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only be validly
taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which may be
represented).
17.7. The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in
writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be
the date of the last signature.
Art. 18. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
18.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by
the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. In the event the general meeting of
shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) under the joint
signature of one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation). Copies or excerpts
of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if any, or
by any two (2) managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers
(namely class A manager and class B manager) under the joint signatures of one (1) class A manager and one (1) class B
manager (including by way of representation).
18.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.
121029
L
U X E M B O U R G
Art. 19. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the
signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers;
in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers
and class B managers), the Company will only be validly bound by the joint signatures of at least one (1) class A manager
and one (1) class B manager (including by way of representation) or (ii) by the joint signatures or the sole signature of
any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such
delegation.
E. Audit and supervision
Art. 20. Auditor(s).
20.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company
shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.
20.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting
of shareholders.
20.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
20.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d’entreprises agréé
(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies’ register and the
accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.
20.5. An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its
approval.
F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends
Art. 21. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end
on the thirty-first of December of the same year.
Art. 22. Annual accounts and allocation of profits.
22.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of
the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.
22.2. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve.
This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten
per cent (10%) of the share capital of the Company.
22.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the
contributing shareholder agrees with such allocation.
22.4 In case of a share capital reduction, the Company’s legal reserve may be reduced in proportion so that it does
not exceed ten per cent (10%) of the share capital.
22.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the
remainder of the Company’s profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.
22.6 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.
Art. 23. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
23.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared
by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may
not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable
reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles
of association do not allow to be distributed.
23.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the share-
holders subject to the provisions of the Law and these articles of association.
G. Liquidation
Art. 24. Liquidation.
24.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the
liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders
deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided,
the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the
Company.
24.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among
the shareholders in proportion to the number of shares of the Company held by them.
121030
L
U X E M B O U R G
H. Final clause - Governing law
Art. 25. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance
with the Law.
<i>Transitional provisionsi>
1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 31 December
2014.
2. Interim dividends may be distributed during the Company’s first financial year.
<i>Subscription and paymenti>
The twelve thousand five hundred (12,500) shares issued have been subscribed by Digital Services XXVIII S.à r.l.,
aforementioned, for the price of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500).
The shares so subscribed are fully paid-up by a contribution in cash so that the amount of twelve thousand five hundred
euro (EUR 12,500) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
The total contribution in the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) is entirely allocated to the
share capital.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be
borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately one thousand Euros (EUR
1,000.-).
<i>Resolution of the sole shareholderi>
The incorporating shareholder, representing the entire share capital of the Company and having waived any convening
requirements, has thereupon passed the following resolutions:
1. The address of the registered office of the Company is set at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of
Luxembourg.
2. The following person is appointed as class A manager of the Company for an unlimited term:
- Mr Christian Senitz, born in Aschersleben, Germany, on 27 January 1978, professionally residing at Johannisstrasse
20, D-10117 Berlin.
The following person is appointed as class B manager of the Company for an unlimited term:
- Mr Ulrich Binninger, born in Trier, Germany, on 30 August 1966, professionally residing at 19, rue des Lilas, L-8035
Strassen, Luxembourg.
<i>Statementi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,
this deed is worded in English followed by a German translation; at the request of the same appearing party and in case
of divergence between the English and the German text, the English version shall prevail.
WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this
document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name
and residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:
Im Jahr zweitausendvierzehn, am achtzehnten Juni.
Vor uns, Carlo WERSANDT, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
IST ERSCHIENEN:
Digital Services XXVIII S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), gegründet
und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Groß-
herzogtum Luxemburg, deren Eintragung im Luxemburger Handels-und Gesellschaftsregister noch aussteht,
hier vertreten durch Herrn Luis AGUERRE ENRÍQUEZ, Doctor en Derecho, wohnhaft in Luxemburg, gemäß einer
Vollmacht ausgestellt in Berlin, Deutschland, am 18. Juni 2014 und in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, am 18.
Juni 2014.
Besagte Vollmacht, welche vom Bevollmächtigten der erschienenen Partei und dem unterzeichnenden Notar ne vari-
etur paraphiert wurde, wird der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.
Die erschienene Partei hat den amtierenden Notar ersucht, die Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung
(société à responsabilité limitée) zu beurkunden, welche sie mit der folgenden Satzung gründen möchte:
121031
L
U X E M B O U R G
A. Name - Zweck - Dauer - Sitz
Art. 1. Name - Rechtsform. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée)
mit dem Namen Digital Services XXVIII (GP) S.à r.l. (die „Gesellschaft”), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom
10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung
unterliegt.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Ge-
sellschaften, sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung
oder auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung,
Kontrolle und Entwicklung ihrer Beteiligungen im Hinblick auf deren Verwertung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige
Art.
2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder
Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören Garantien geben,
Sicherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.
2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere
durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und
Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheinen bzw. Wertpapieren.
2.4 Die Gesellschaft kann auch als Gesellschafterin für die Schulden und Verpflichtungen jeglicher luxemburgischen
und ausländischen Gesellschaft mit unbeschränkter oder beschränkter Haftung handeln.
2.5 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur vorneh-
men, sowie solche, welche das geistige Eigentum betreffen oder im Zusammenhang mit Grundeigentum stehen, und die
ihr zur Erreichung dieser Zwecke förderlich erscheinen.
Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden,
welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird.
Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Rates der Geschäftsführer
verlegt werden. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderli-
chen Art und Weise gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.
4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer im
Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.
4.4 Sollte der Rat der Geschäftsführer entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale
Entwicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an
ihrem Gesellschaftssitz beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz bis zur endgültigen Beendigung dieser
außergewöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben
keine Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes
eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.
B. Gesellschaftskapital - Anteile
Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) bestehend aus
zwölftausendfünfhundert (12.500) Anteilen mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Anteil.
5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-
zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.
5.3 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen.
Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit jeweils dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht über-
schreiten darf.
6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs, die Insolvenz
oder ein vergleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.
121032
L
U X E M B O U R G
Art. 7. Anteilsregister - Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden
kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.
7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten
wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft
ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.
7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.
7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern mit
einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden.
7.5 Jede Übertragung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten gemäß Artikel 1690 des Code Civil
wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung zugestimmt
hat.
7.6 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters an neue Gesellschafter nur mit Zustimmung von
Gesellschaftern mit einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden. Eine derartige Zu-
stimmung ist nicht erforderlich, wenn die Anteile Eltern, Nachkommen oder dem/der überlebenden Ehepartner/in oder
jedem anderen gesetzlichen Erben des verstorbenen Gesellschafters übertragen werden.
C. Entscheidungen der Gesellschafter
Art. 8. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
8.1 Die Gesellschafterversammlung ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch das Gesetz und diese Satzung
ausdrücklich vorbehalten sind.
8.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.
8.3 Falls und solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, dürfen gemeinsame Ent-
scheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung vorbehalten wären, schriftlich gefasst werden. In diesem
Fall erhält jeder Gesellschafter den Text der zu fassenden Beschlüsse oder Entscheidungen in ausformulierter Form und
übt sein Stimmrecht schriftlich aus.
8.4 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschriften
des Abschnitts XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jede Bezugnahme auf die „Gesell-
schafterversammlung“ in der vorliegenden Satzung als Bezugnahme auf den Alleingesellschafter, je nach Zusammenhang
und soweit anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingesellschafter
ausgeübt.
Art. 9. Gesellschafterversammlung. Falls die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, muss jährlich
innerhalb von sechs (6) Monaten vor dem Ende des Geschäftsjahres mindestens eine Gesellschafterversammlung in Lu-
xemburg am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort abgehalten werden, wie in der Einberufungsbekanntmachung
zu dieser Versammlung genauer bestimmt. Andere Gesellschafterversammlungen finden an dem Ort und zu der Zeit statt,
welche in der entsprechenden Einberufungsbekanntmachung genauer bestimmt werden. Falls alle Gesellschafter in einer
Versammlung anwesend oder vertreten sind und auf sämtliche Einberufungsformalitäten verzichtet haben, kann die Ge-
sellschafterversammlung auch ohne vorherige Ankündigung oder Veröffentlichung abgehalten werden.
Art. 10. Quorum und Abstimmung.
10.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.
10.2 Vorbehaltlich anderer Regelungen dieser Satzung oder des Gesetzes, die ein höheres Mehrheitsverhältnis vor-
sehen, bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von Gesellschaftern, die mehr als die
Hälfte des Gesellschaftskapitals halten. Falls diese Mehrheit in einer ersten Gesellschafterversammlung oder einer ersten
schriftlichen Konsultation der Gesellschafter nicht erreicht wird, können die Anteilseigner ein weiteres Mal mit derselben
Tagesordnung einberufen werden oder per Einschreiben dieselben schriftlichen Beschlussvorschläge erhalten und Ent-
scheidungen werden wirksam mit der Mehrheit der wirksam abgegebenen Stimmen gefasst, unabhängig vom Anteil des
durch sie vertretenen Gesellschaftskapitals.
Art. 11. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.
Art. 12. Änderung der Satzung. Eine Änderung der Satzung erfordert die Zustimmung (i) einer Mehrheit der Gesell-
schafter, (ii) die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertritt.
D. Geschäftsführung
Art. 13. Befugnisse des alleinigen Geschäftsführers - Zusammensetzung und Befugnisse des Rates der Geschäftsführer.
13.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Ge-
schäftsführer hat, bilden diese einen Rat der Geschäftsführer.
121033
L
U X E M B O U R G
13.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „alleiniger Ge-
schäftsführer“ nicht ausdrücklich verwendet wird, ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Rat der Geschäftsführer“
als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer“ auszulegen.
13.3 Der Rat der Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, im Namen der Gesellschaft zu handeln
und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.
Art. 14. Ernennung, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
14.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung ernannt, welche ihre Bezüge und
Amtszeit festlegt.
14.2 Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund durch einen Beschluss von Gesellschaftern, die mehr als die
Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, ernannt oder abberufen werden.
14.3 Die Gesellschafterversammlung kann die Ernennung von Geschäftsführern zwei (2) unterschiedlicher Kategorien
beschließen, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Eine solche Klassifizierung
der Geschäftsführer muss ordnungsgemäß im Protokoll der betreffenden Gesellschafterbeschlüsse festgehalten und die
Geschäftsführer der Kategorie, der sie angehören, zugeordnet werden.
Art. 15. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
15.1 Scheidet ein Geschäftsführer durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Insolvenz, Rücktritt oder aus einem anderen Grund
aus seinem Amt aus, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen die ur-
sprüngliche Amtszeit nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesellschafterversammlung ausgefüllt werden,
welche im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die endgültige Ernennung entscheidet.
15.2 Für den Fall, dass der alleinige Geschäftsführer aus seinem Amt ausscheidet, muss die frei gewordene Stelle
unverzüglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.
Art. 16. Einladung zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
16.1 Der Rat der Geschäftsführer versammelt sich auf Einberufung eines beliebigen Geschäftsführers. Die Sitzungen
des Rates der Geschäftsführer finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.
16.2 Die Geschäftsführer werden mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung anberaumten
Zeitpunkt zu jeder Sitzung des Rates der Geschäftsführer schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe
der Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Geschäftsführer
schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abgege-
ben haben, wobei eine Kopie eines solchen unterzeichneten Dokuments ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung
zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss
des Rates der Geschäftsführer bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.
16.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle
Einladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Rates
der Geschäftsführer diesen zugestimmt und diese unterzeichnet haben.
Art. 17. Durchführung von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
17.1 Der Rat der Geschäftsführer kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Rat der Ge-
schäftsführer kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise selbst ein Geschäftsführer sein muss
und der für die Protokollführung der Sitzungen des Rates der Geschäftsführer verantwortlich ist.
17.2 Sitzungen des Rates der Geschäftsführer werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Rates der Ge-
schäftsführer geleitet. In dessen Abwesenheit kann der Rat der Geschäftsführer einen anderen Geschäftsführer durch
einen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Mitglieder als Vorsitzenden pro tempore ernennen.
17.3 Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer teilnehmen, indem er einen anderen
Geschäftsführer schriftlich, per Faxschreiben, EMail oder durch ein anderes vergleichbares Kommunikationsmittel be-
vollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Geschäftsführer kann einen
oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.
17.4 Eine Sitzung des Rates der Geschäftsführer kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein
anderes Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu
hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel
ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung gilt als am Sitz der Ge-
sellschaft abgehalten.
17.5 Der Rat der Geschäftsführer kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest die Mehrheit seiner
Mitglieder in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.
17.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Rates der Geschäftsführer
teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden,
hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme. Sofern die Gesellschafterversammlung jedoch unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
121034
L
U X E M B O U R G
der Kategorie B), werden Beschlüsse des Rates der Geschäftsführer nur dann wirksam gefasst, wenn sie von der Mehrheit
der Geschäftsführer einschließlich mindestens eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsführers der
Kategorie B (oder deren Vertreter) gefasst werden.
17.7 Der Rat der Geschäftsführer kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung,
per Faxschreiben, E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Jeder Geschäftsführer kann seine
Zustimmung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreffenden
Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.
Art. 18. Protokoll von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer - Protokoll der Entscheidungen des alleinigen Ge-
schäftsführers.
18.1 Das Protokoll einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer wird vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer,
falls vorhanden, oder, im Falle seiner Abwesenheit, vom Vorsitzenden pro tempore und dem Schriftführer (falls vorhan-
den) oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche
Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kate-
gorie B), werden solche Protokolle von einem (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einem (1) Geschäftsführer der
Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsver-
fahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer, falls
vorhanden, oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden solche Kopien oder Auszüge von einem (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einem (1)
Geschäftsführer der Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet.
18.2 Die Entscheidungen des alleinigen Geschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom alleinigen
Geschäftsführer unterzeichnet wird. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet.
Art. 19. Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Um-
ständen (i) durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder, für den Fall, dass die Gesellschaft mehrere
Geschäftsführer hat, durch die gemeinsame Unterschrift von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern wirksam verpflichtet;
sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäfts-
führer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B), wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift
mindestens eines (1) Geschäftsführers der Kategorie A und eines (1) Geschäftsführers der Kategorie B (oder deren
Vertreter) oder (ii) durch die gemeinsamen Unterschriften oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/denen
eine Unterschriftsbefugnis durch den Rat der Geschäftsführer übertragen worden ist, wirksam verpflichtet.
E. Aufsicht und Prüfung der Gesellschaft
Art. 20. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
20.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der
Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)). Die Gesellschafterversammlung
ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.
20.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
20.3 Der Rechnungsprüfer hat ein unbeschränktes Recht der permanenten Überprüfung und Kontrolle aller Geschäfte
der Gesellschaft.
20.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember
2002 betreffend das Handelsregister und die Buchhaltung und den Jahresabschluss von Unternehmen, in der jeweils
gültigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseur(s) d’entreprises agréé(s)) ernennen, entfällt
die Funktion des Rechnungsprüfers.
20.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die
Gesellschafterversammlung abberufen werden.
F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinne - Abschlagsdividenden
Art. 21. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am
einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.
Art. 22. Jahresabschluss und Gewinne.
22.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Rat der Geschäftsführer erstellt im
Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und
Verlustrechnung.
22.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage
der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.
22.3 Durch einen Gesellschafter erbrachte Einlagen in Rücklagen können mit Zustimmung dieses Gesellschafters
ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.
121035
L
U X E M B O U R G
22.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage entsprechend herabgesetzt
werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.
22.5 Auf Vorschlag des Rates der Geschäftsführer bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den ge-
setzlichen Vorschriften und den Bestimmungen dieser Satzung, wie der verbleibende Bilanzgewinn der Gesellschaft
verwendet werden soll.
22.6 Ausschüttungen an die Gesellschafter erfolgen proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehalt-
enen Anteile.
Art. 23. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
23.1 Der Rat der Geschäftsführer kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche
vom Rat der Geschäftsführer vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur
Verfügung stehen. Der ausschüttbare Betrag darf nicht die Summe der seit dem Ende des vergangenen Geschäftsjahres
angefallenen Gewinne, gegebenenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne und ausschüttbare Rücklagen, beziehungs-
weise vermindert durch vorgetragene Verluste und Summen, die einer Rücklage zugeführt werden, welche nach dem
Gesetz von 1915 oder dieser Satzung nicht ausgeschüttet werden darf, übersteigen.
23.2 Das Agio, andere Kapitalreserven oder andere ausschüttbare Rücklagen können im Einklang mit den Bestimmun-
gen des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.
G. Liquidation
Art. 24. Liquidation.
24.1 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Liquidation durch einen
oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, die über die Auflö-
sung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit nichts anderes
bestimmt wird, haben die Liquidatoren die weitestgehenden Rechte für die Verwertung der Vermögenswerte und die
Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
24.2 Der sich nach Verwertung der Vermögenswerte und Tilgung der Verbindlichkeiten ergebende Überschuss wird
an die Gesellschafter proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehaltenen Anteile verteilt.
H. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht
Art. 25. Anwendbares Recht. Für alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten gelten die Regelungen des
Gesetzes von 1915.
<i>Übergangsbestimmungeni>
1. Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember
2014.
2. Abschlagsdividenden können auch während des ersten Geschäftsjahres der Gesellschaft ausgeschüttet werden.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Die zwölftausendfünfhundert (12.500) ausgegebenen Anteile wurden von Digital Services XXVIII S.à r.l., vorbenannt,
zum Preis von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) gezeichnet.
Die Einlage für so gezeichnete Anteile wurde vollständig in bar erbracht, so dass der Gesellschaft ein Betrag in Höhe
von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) zur Verfügung steht, was dem unterzeichnenden Notar nachgewiesen
wurde.
Die gesamte Einlage in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) wird vollständig dem Gesellschaftskapital
zugeführt.
<i>Auslageni>
Die der Gesellschaft aufgrund oder im Zusammenhang mit ihrer Gründung entstandenen Kosten, Gebühren, Honorare
und Auslagen werden auf eintausend Euro (EUR 1.000) geschätzt.
<i>Beschlüsse des Alleingesellschaftersi>
Der Gründungsgesellschafter, welcher das gesamte Gesellschaftskapital repräsentiert und welcher auf eine formelle
Einberufungsbekanntmachung verzichtet, hat daraufhin folgende Beschlüsse gefasst:
1. Der Sitz der Gesellschaft ist in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
2. Die folgende Person wird für unbegrenzte Zeit als Geschäftsführer der Kategorie A der Gesellschaft ernannt:
- Herr Christian Senitz, geboren am 27. Januar 1978 in Aschersleben, Deutschland, geschäftsansässig in Johannisstraße
20, D-10117 Berlin.
Die folgende Person wird für unbegrenzte Zeit als Geschäftsführer der Kategorie B der Gesellschaft ernannt:
- Herr Ulrich Binninger, geboren am 30. August 1966 in Trier, Deutschland, geschäftsansässig in 19, rue des Lilas,
L-8035 Strassen, Luxemburg.
121036
L
U X E M B O U R G
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache beherrscht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende
Urkunde auf Verlangen der erschienenen Partei auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung;
auf Verlangen besagter erschienener Partei und im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen
Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.
WORÜBER diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen wurde.
Die vorstehende Urkunde ist dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei, welcher dem Notar mit Namen, Vorn-
amen und Wohnsitz bekannt ist, verlesen und vom Notar gemeinsam mit diesem Bevollmächtigten unterzeichnet worden.
Signé: L. AGUERRE ENRIQUEZ, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 juin 2014. LAC/2014/28990. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri>
(signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
Luxembourg, le 8 juillet 2014.
Référence de publication: 2014103029/578.
(140121673) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2014.
Compass Printing S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 283.286,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 159.171.
In the year two thousand and fourteen on the tenth day of July.
Before Us, Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Neuheim Lux Group Holding V, a private limited liability company (société à responsabilité limitée) established and
existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 1B Heienhaff, L- 1736 Sennin-
gerberg, Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of EUR 8.624.430,00 and registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register under number B 137498 (Neuheim);
here represented by Ms. Claudia Rouckert, employee, with professional address at 5, rue Zénon Bernard, L- 4030
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of 1 proxy given under private seal on July 8, 2014.
The said proxy signed ne varietur by the proxyholder of the persons appearing and the undersigned notary, will remain
attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing persons, represented as stated hereabove, have requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing person is the sole shareholder of the private limited liability company established and existing in the
Grand Duchy of Luxembourg under the name of “Compass Printing S.à r.l.” (the Company), with registered office at 5,
rue Guillaume Kroll L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of EUR 226.501,00 and
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 159171, established pursuant to a deed
of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, dated January 14, 2011, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations under number 1068 dated May 05, 2011 and whose bylaws have been last amended by a
deed of the undersigned notary dated December 3, 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions under number 505 dated February 25, 2014.
II. The Company's share capital is set at EUR 226.501,00 represented by 226.501 shares with a nominal value of one
Euro (EUR 1,00) each.
III. The shareholder resolves to create two different classes of shares namely the class A shares (the Class A Shares)
and the class B shares (the Class B Shares).
IV. The shareholder resolves to convert the 226.501 ordinary shares with a nominal value of EUR 1,00 each, issued
by the Company, into 226.501 Class A Shares with a nominal value of EUR 1,00 each.
V. The shareholder resolves to increase the Company's share capital by an amount of EUR 56.785,00 in order to raise
it from its present amount of EUR 226.501,00 to EUR 283.286,00, by the creation and issuance of 56.785 Class B Shares,
having a nominal value of EUR 1,00 each (the New Class B Shares).
<i>Subscription - Paymenti>
Neuheim, though its proxyholder, resolves to subscribe for the New Class B Shares, and to fully pay them up in the
amount of GBP 45.000,00 being the equivalent amount of EUR 56.785,00 based on the exchange rate GBP 1.26188 to
EUR 1,00 as at July 7, 2014, by payment in kind consisting in the contribution of a receivable in the same amount held by
Neuheim towards the Company which receivable is incontestable payable and due (the Receivable).
121037
L
U X E M B O U R G
<i>Evidence of the contribution's existence and valuei>
Proof of the existence and value of the contribution in kind has been given by a contribution declaration of Neuheim,
attesting that it is the unrestricted owner of the Receivable.
<i>Effective implementation of the contribution in kindi>
It appears from that declaration of Neuheim that:
- it is the sole unrestricted owner of the Receivable to be contributed and possesses the power to dispose of it, it
being legally and conventionally freely transferable;
- the Receivable has consequently not been transferred and no legal or natural person other than Neuheim, is entitled
to any rights as to the Receivable;
- all further formalities are in course in the jurisdiction of the location of the Receivable in order to duly carry out and
formalize the contribution and to render it effective anywhere and toward any third party.
<i>Report of the Company's managersi>
The report of the managers of the Company, dated July 9
th
, 2014, annexed to the present deed, attests that the
managers of the Company, acknowledging having been informed beforehand of the extent of their responsibility, legally
bound as managers of the Company owing the above described contribution in kind, expressly agree with its description,
with its valuation and confirm the validity of the subscription and payment.
VI. Following the above, the shareholder resolves to amend article 6 of the Company's articles of to give it henceforth
the following content:
“ Art. 6. The Company's share capital is set at EUR 283.286,00 represented by the following shares:
- 226.501 class A ordinary shares with a nominal value of one EUR 1,00 (the Class A Shares);
- 56.785 class B ordinary shares with a nominal value of one EUR 1,00 each (the Class B Shares);
The Class A and Class B Shares are together referred to as the Shares, and the above listed Class A and Class B Shares
are together referred to as the Share Classes.
The holder of the Shares is referred to as the Shareholder.
In addition to the share capital, the Company shall have:
- two (2) share premium accounts (each, a Share Premium Account), one for each Share Class, into which any premium
paid on any Class A or Class B Share is transferred and the balance on which each corresponding holder(s) has exclusive
entitlement to; and
- two (2) capital contribution accounts (each, a Capital Contribution Account), one for each Share Class, into which
any capital contributed by a Shareholder in addition to its shareholding is transferred and the balance on which each
corresponding holder(s) has exclusive entitlement to.
The Share Premium Accounts and the Capital Contribution Accounts are at the free disposal of the Shareholder, who
shall freely decide on any movements relating thereto, either debit or credit, through ordinary resolutions taken in
compliance with article 15.”
VII. The shareholder resolves to acknowledge that the existing capital contribution in the amount of EUR 40.552,00
having an equivalent amount of GBP 35.000,00 made by Neuheim, with effect as of February 15, 2013, shall be linked to
the Class B Shares.
VIII. Following the above, the shareholder resolves to amend article 18 of the articles of association of the Company
to be read as follows:
“ Art. 18. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortization,
charges and provisions represents the net profit of the Company.
Every year, five percent (5%) of the net profit shall be transferred to the legal reserve. This deduction ceases to be
compulsory when the legal reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital but shall be resumed until
the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatsoever, the ten percent (10%) threshold
is no longer met.
The balance of the net profit may be distributed to the shareholder or to the shareholders in proportion to its
shareholding in the Company and as follows:
- any net profit deriving from the financing activity carried out by the fully owned subsidiary of the Company, Compass
Delta Holdings Limited a limited liability company established and existing under the laws of United Kingdom, having its
registered office at 2, Park Street, 1
st
Floor, London W1K 2HX, England and registered with the Companies House of
England and Wales under number 9092061 (the Subsidiary), shall be exclusively distributed to the holder of Class B Shares;
- any other net profit deriving from the shareholding of the Company in the Subsidiary shall be exclusively distributed
to the holder of Class A Shares.
Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by Law and by the present article.”
121038
L
U X E M B O U R G
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxy holder of
the above appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the
same persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Esch/Alzette, on the date first written above.
The document having been read to the proxy holder of the appearing persons, who is known to the notary by her full
name, civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quatorze, le dix juillet.
Par- devant Nous, Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
Neuheim Lux Group Holding V, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social
au 1B Heienhaff, L- 1736 Senningerberg, Grand- Duché de Luxembourg, ayant un capital social de EUR 8.624.430,00 et
enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 137498 (Neuheim);
ici représentés par Mlle. Claudia Rouckert, employée privée, ayant son adresse professionnelle au 5, rue Zénon Ber-
nard, L- 4030, Esch/Alzette, Grand- Duchy of Luxembourg en vertu de 1 procuration donnée sous seing privé le 8 Juillet
2014.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instru-
mentant, annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.
Lequel comparant, représenté comme indiqué ci- dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter que:
I. Le comparant est l'associé unique de la société à responsabilité limitée établie en vertu des lois du Luxembourg sous
la dénomination «Compass Printing S.à r.l.» (la Société), ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll L-1882 Luxem-
bourg, Grand- Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 159171, constituée par acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire résidant à Luxembourg, en date
du 14 janvier 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1068 en date du 5 mai
2011 et dont les statuts ont été modifiés dernièrement par un acte du notaire instrumentaire en date du 3 décembre
2013 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association sous le numéro 505 en date du 25 février 2014.
II. Le capital social de la Société est fixé à la somme de EUR 226.501,00 représenté par 226.501 parts sociales d'une
valeur nominale de EUR 1,00 chacune.
III. L'associé unique décide de créer deux classes différentes de parts sociales dénommées les parts sociales de classe
A (les Parts Sociales de Classe A) et les parts sociales de classe B (les Parts Sociales de Classe B).
IV. L'associé unique décide de convertir les 226.501 parts sociales ordinaires d'une valeur nominale de EUR 1,00
chacune, émises par la Société, en 226.501 Parts Sociales de Classe A d'une valeur nominale de EUR 1,00 chacune.
V. L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de EUR 56.785,00 pour le porter
de son montant actuel de EUR 226.501,00 à EUR 283.286,00 par la création et l'émission de 56.785 Parts Sociales de
Classe B d'une valeur nominale de EUR 1,00 chacune (les Nouvelles Parts Sociales de Classe B).
<i>Souscription - Libérationi>
Neuheim, précité, par l'intermédiaire de son mandataire précité, décide de souscrire les Nouvelles Parts Sociales de
Classe B, et de les libérer intégralement d'un montant total de GBP 45.000,00 équivalent à la somme de EUR 56.785,00
suivant le taux de change de GBP 1.26188 pour EUR 1,00 au 7 juillet 2014, par un apport en nature consistant en l'apport
d'une créance du même montant détenue par Neuheim, à l'égard de la Société, laquelle créance est certaine, liquide et
exigible (la Créance)
<i>Preuve de l'existence et de la valeur de l'apporti>
Preuve de l'existence et de la valeur de cet apport en nature a été donnée par une déclaration d'apport de Neuheim,
certifiant qu'il est propriétaire sans restriction de la Créance.
<i>Réalisation effective de l'apporti>
Il résulte de la prédite déclaration d'apport de Neuheim que:
- il est seul propriétaire sans restriction de la Créance apportée et possède les pouvoirs d'en disposer, celle- ci étant
légalement et conventionnellement librement transmissible;
- la Créance n'a pas fait l'objet d'une quelconque cession et aucune personne morale ou physique autre que Neuheim,
ne détient de droit sur la Créance;
- toutes autres formalités sont en cours de réalisation dans la juridiction de situation de la Créance aux fins d'effectuer
son apport et le rendre effectif partout et vis- à- vis de tous tiers.
121039
L
U X E M B O U R G
<i>Rapport des gérants de la Sociétéi>
Le rapport des gérants de la Société en date du 9 juillet 2014, annexé aux présentes, atteste que les gérants de la
Société, reconnaissant avoir pris connaissance de l'étendue de leur responsabilité, légalement engagés en leur qualité de
gérants de la Société à raison de l'apport en nature décrit plus haut, marquent expressément leur accord sur la description
de l'apport en nature, sur son évaluation et confirment la validité des souscriptions et libérations.
VI. Suite à quoi, l'associé unique décide de modifier l'article 6 des statuts de la Société, désormais rédigé comme suit:
" Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à la somme de EUR 283.286,00 représenté par les parts sociales suivantes:
- 226.501 parts sociales de classe A ayant une valeur nominale de EUR 1,00 (les Parts Sociales de Classe A);
- 56.785 parts sociales de classe B ayant une valeur nominale de EUR 1,00 chacune (les Parts Sociales de Classe B)
Il est référé à l'ensemble des Parts Sociales de Classe A et des Parts Sociales de Classe B en tant que Parts Sociales,
et aux Parts Sociales de Classe A et Parts Sociales de Classe B listées ci- dessus en tant que Classes de Parts Sociales.
Il est référé au détenteur des Parts Sociales comme l'Associé.
En plus du capital social, la Société a:
- deux (2) comptes de prime d'émission (chacun, un Compte de Prime d'Emission), un pour chaque Classe de Parts
Sociales, sur lesquels toute prime d'émission payée pour toute Part Sociale de Classe A ou Part Sociale de Classe B est
transférée, et dont chaque détenteur a un droit exclusif; et
- deux (2) comptes d'apport en capitaux propres non rémunéré par des titres (chacun, un Compte d'Apport), un pour
chaque Classe de Parts Sociales sur lesquels tout apport en capitaux propres non rémunéré par des titres effectué par
un Associé en sus de sa participation existante est crédité, et dont chaque détenteur a un droit exclusif.
Les Comptes de Prime d'Emission et les Comptes d'Apport sont à la libre disposition de l'Associé, qui décident de
tout mouvement y relatif, débit ou crédit, par résolution ordinaire prise conformément à l'article 15.
VII. L'associé unique décide de reconnaître que l'apport en compte de capital contribution existant d'un montant de
EUR 40.552,00 ayant un montant équivalent de GBP 35.000,00 effectué par Neuheim avec effet au 15 février 2013, doit
être lié aux a Parts Sociales de Classe B.
VIII. Suite à quoi, l'associé unique décide de modifier l'article 18 des statuts de la Société, pour lui donner la teneur
suivante:
« Art. 18. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et
provisions, constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net sont affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cessent d'être obligatoires lorsque la réserve légale atteint dix pour cent (10%) du capital social,
mais doivent être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds
de réserve se trouve entamé.
Le solde du bénéfice net peut être distribué aux associés, au prorata de leur participation dans la Société, et de la façon
suivante:
- tout bénéfice net dérivant de l'activité de financement réalisée par la filiale de la Société, Compass Delta Holdings
Limited, une société à responsabilité limitée de droit anglais, ayant son siège social au 2 Park Street, 1
st
Floor, Londres
W1K 2HX, Royaume Uni et enregistrée auprès du Companies House for England and Wales sous le numéro 9092061
(la Filiale), est distribué de façon exclusive aux détenteurs de Parts Sociales de Classe B;
- tout autre bénéfice net dérivant de la détention par la Société de parts sociales de classe A de la Filiale est distribué
de façon exclusive aux détenteurs d'Actions de Classe A.
Des dividendes intérimaires pourront être distribués en observant les conditions légales et du présent article.»
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête du mandataire des
personnes comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête des mêmes
personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des personnes comparantes, connu du notaire par son nom et
prénom, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire, le présent acte.
Signé: Rouckert, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 14 juillet 2014. Relation: EAC/2014/9735. Reçu soixante- quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. Halsdorf.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2014104740/202.
(140125481) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2014.
121040
L
U X E M B O U R G
Compass International Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: CAD 34.000,00.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 143.873.
DISSOLUTION
In the year two thousand and fourteen, on the tenth day of July,
before Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,
THERE APPEARED:
North American Salt Company, a Foreign For Profit company incorporated under the laws of the United States of
America, having its registered office at 9900 West 109
th
Street, Suite 100, Overland Park, Kansas 66210, registered with
the Kansas Trade and Companies Registry under the number 7375934 (the Sole Shareholder),
hereby represented by Ms. Claudia Rouckert, employee, professionally residing in Esch-sur-Alzette, by virtue of a proxy
given under private seal (the Proxyholder).
Said proxy, after having been signed ne varietur by the Proxyholder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.
The Sole Shareholder, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:
(1) Compass International Holdings S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité
limitée), having its registered office at 174, Route de Longwy, registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register under the number B 143.873, and having a share capital of CAD 34,000, was incorporated on 19 December
2008 by a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number176 dated 27 January 2009. The articles of association of the
Company have never been amended.
(2) The corporate capital of the Company is set at CAD 34,000 (thirty- four thousand Canadian Dollars) divided into
3,400 (three thousand four hundred) ordinary shares having a nominal value of CAD 10 (ten Canadian Dollars) each.
(3) The Sole Shareholder, prenamed, is the sole owner of all the shares of the Company.
(4) The Sole Shareholder, acting in its capacity as sole shareholder of the Company, resolves to dissolve the Company
with immediate effect.
(5) The Sole Shareholder appoints Halsey S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsa-
bilité limitée), having its registered office at 174, Route de Longwy, L- 1940 Luxembourg, having a share capital of EUR
12,500, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Registry under the number B 50.984, as liquidator of
the Company (the Liquidator); the Liquidator will have full powers to sign, execute and deliver any acts and any documents,
to make any declaration and to do anything necessary or useful so to bring into effect the purposes of the present deed.
(6) The Liquidator reports that, as of the date hereof, the Company's main assets and liabilities, as shown in the
liquidation accounts dated 7 July 2014, are the following:
- Assets amounting to CAD 38,052.14; and
- Liabilities amounting to CAD 111,545.08 (the Liabilities).
(7) The Sole Shareholder declares that the Liabilities are composed as follows:
- Liability against the Sole Shareholder in an amount of CAD 109,627.38; and
- Liability corresponding to the liquidation fees in an amount of CAD 1,917.70.
(8) The Sole Shareholder declares that except the Liabilities, all liabilities towards third parties known to the Company,
have been entirely paid or are duly accounted for and that it irrevocably undertakes to settle any presently unknown and
unpaid liability of the dissolved Company.
(9) The Sole Shareholder subsequently declares that it has taken over all the assets and outstanding liabilities of the
Company, together with the profit and loss account of the Company, so that all assets and liabilities of the Company are
transferred to the Sole Shareholder with immediate effect.
(10) The Sole Shareholder resolves to waive its right to appoint an auditor to the liquidation (commissaire à la liqui-
dation) in charge of reporting on the liquidation operations carried out by the Liquidator and thus declares that there is
no need to hold a second general meeting and resolves to hold immediately the third and last general meeting.
(11) The Sole Shareholder resolves to grant full discharge (quitus) to the managers of the Company and to the Liqui-
dator for the exercise of their respective mandates.
(12) The Sole Shareholder resolves that the liquidation of the Company is closed and that any registers of the Company
recording the issuance of shares or any other securities shall be cancelled.
(13) The books and documents of the Company will be kept for a period of five years in Luxembourg at the registered
office of the Liquidator.
121041
L
U X E M B O U R G
In accordance, the appearing person, acting in his said capacity, requires the undersigned notary to state the above-
mentioned declarations.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn in Esch-sur-Alzette, on the year and day first above written.
The document having been read to the Proxyholder, known to the notary by first name, last name, civil status and
residence, the said Proxyholder signed together with the notary the present notarial deed.
Suit la version française du texte qui précède
L'an deux mille quatorze, le dixième jour du mois de juillet,
Par devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand- Duché de Luxembourg,
A COMPARU:
North American Salt Company, une société étrangère à but non lucratif de droit des Etats Unis d'Amérique, ayant son
siège social au 9900 West 109
th
Street, Suite 100, Overland Park, Kansas 66210, immatriculée auprès du Registre de
Commerce du Kansas sous le numéro 7375934 (l'Associé Unique),
représenté par Mlle. Claudia Rouckert, employée privée, résidant professionnellement à Esch-sur-Alzette, en vertu
d'une procuration donnée sous seing privé (le Mandataire).
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le Mandataire agissant au nom de la partie requérante et le
notaire instrumentaire, demeurera annexée au présent acte pour être enregistrée ensemble avec celui- ci auprès des
autorités compétentes.
L'Associé Unique, représenté comme décrit ci- dessus, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
(1) Compass International Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son
siège social au 174, Route de Longwy, L- 1940 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 143.873 et ayant un capital social de 34.000 CAD, a été constituée le 19 décembre
2008 suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand- Duché de Luxembourg,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 176 du 27 janvier 2009. Les statuts de la Société
n'ont jamais été modifiés.
(2) Le capital social de la Société est fixé à 34.000 CAD (trente- quatre mille Dollars Canadiens) divisé en 3.400 (trois
mille quatre cents) parts sociales ordinaires de la Société, ayant une valeur nominale de 10 CAD (dix Dollars Canadiens)
chacune.
(3) L'Associé Unique, préqualifié, est l'unique propriétaire de toutes les parts sociales de la Société.
(4) L'Associé Unique, agissant en tant que l'associé unique, décide de dissoudre la Société avec effet immédiat.
(5) L'Associé Unique désigne Halsey S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son
siège social au 174, Route de Longwy, L- 1940 Luxembourg, ayant un capital social de 12.500 EUR et immatriculée auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 50.984, comme liquidateur de la Société (le
Liquidateur); que le Liquidateur aura pleins pouvoirs d'établir, signer, exécuter et délivrer tous actes et documents, de
faire toute déclaration et de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour mettre en exécution les dispositions du présent
acte.
(6) Le Liquidateur déclare que l'actif et le passif de la Société, sur base des comptes de liquidation datés du 7 juillet
2014, sont les suivants:
- l'actif s'élève à 38.052,14 CAD; et
- le passif s'élève à 111.545,08 CAD (les Dettes).
(7) L'Associé Unique constate que les Dettes se composent comme suit:
- dette envers l'Associé Unique pour un montant de 109.627,38 CAD; et
- dette correspondant aux frais de liquidation pour un montant de 1.917,70 CAD.
(8) L'Associé Unique, déclare qu'à l'exception des Dettes, tout le passif envers les tiers connu de la Société, a été
dûment réglé ou approvisionné et qu'il s'engage irrévocablement à payer tout passif éventuel non encore connu et non
encore payé de la Société dissoute.
(9) L'Associé Unique déclare par conséquent reprendre l'intégralité de l'actif et du passif de la Société, ensemble avec
le compte de profits et pertes de la Société, de sorte que l'actif et le passif de la Société est désormais transféré à l'Associé
Unique avec effet immédiat.
(10) L'Associé Unique décide de renoncer à son droit de nommer un commissaire à la liquidation en charge de faire
un rapport sur les opérations de la liquidation exécutées par le liquidateur de la Société. N'ayant pas besoin de tenir la
deuxième assemblée générale de liquidation, l'Associé Unique décide de fixer à tout de suite la troisième et dernière
assemblée de liquidation.
(11) Décharge est donnée aux gérants de la Société et au Liquidateur quant à l'exercice de leurs mandats respectifs.
121042
L
U X E M B O U R G
(12) L'Associé Unique déclare que la liquidation de la Société est clôturée et que tous les registres de la Société relatifs
à l'émission de parts sociales ou de tous autres titres seront annulés.
(13) Les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq ans à Luxembourg au siège social du Liqui-
dateur.
En conséquence, le comparant, ès- qualité qu'il agit, a requis le notaire de lui donner acte des déclarations ci- dessus.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur la demande de la partie comparante,
le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivie d'une version en langue française, et en cas de divergences entre la
version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Azette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au Mandataire de la partie comparante, connu du notaire par nom,
prénom, état et demeure, ledit Mandataire a signé le présent acte original avec nous, le notaire.
Signé: Rouckert, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 14 juillet 2014. Relation: EAC/2014/9742. Reçu soixante- quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveur ff.i>
(signé): M. Halsdorf.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2014104739/130.
(140125480) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2014.
Chamelon Topco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 188.707.
STATUTES
In the year two thousand and fourteen, on the tenth day of the month of July.
Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
BRE/Europe 7Q S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited liability company) incorporated under the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, having
a share capital of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500) and being registered with the Registre de Commerce
et des Sociétés in Luxembourg under number B180.323,
represented by Maître Flora Verrecchia, lawyer, professionally residing in Luxembourg pursuant to a proxy which shall
be registered together with the present deed.
The appearing party, acting in the above stated capacity, has requested the undersigned notary to draw up the articles
of incorporation of a limited liability company Chameleon Topco S.à r.l. (société à responsabilité limitée) which is hereby
established as follows:
Art. 1. Denomination. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name “Chameleon Topco
S.à r.l.” (the “Company”) is hereby formed by the appearing party and all persons who will become shareholders the-
reafter. The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.
Art. 2. Object. The object of the Company shall be the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg
and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and
development of its portfolio.
The Company may also carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of real estate,
properties and real estate rights in Luxembourg and abroad as well as any participations in any real estate enterprise or
undertaking in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those participa-
tions and assets.
The Company may further give guarantees, grant security interests, grant loans or otherwise assist the companies in
which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may also acquire loans including at a discount, originate loans and lend funds under any form, advance
money or give credit on any terms including without limitation resulting from any borrowings of the Company or from
the issue of any equity or debt securities of any kind to any person or entity as it deems fit in relation to any real estate
enterprise or undertaking. The Company may enter into swaps, futures, forwards, derivatives, options, repurchase, stock
lending and similar transactions, and, without prejudice to the generality of the foregoing, employ any techniques and
instruments in connection with its real estate activities. The Company may also enter into any guarantees, contracts of
121043
L
U X E M B O U R G
indemnities, security interests and any other equivalent agreements in order to receive the benefit of any guarantee and/
or security interest granted in the context of such real estate activities. The Company may undertake any roles necessary
in connection with such lending activity including, without limitation, the role of arranger, lead manager, facility agent,
security agent, documentation agent. The Company shall not undertake such real estate lending or real estate loan
acquisition activities in a way that would require it to be regulated pursuant to the Luxembourg act dated 5 April 1993
on the financial sector, as amended or any future act or regulation amending or replacing such act.
The Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or indirectly
in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purposes.
In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their admi-
nistration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other
advisors.
Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period.
Art. 4. Registered Office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an
extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles of
association.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the
case may be the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the manager, or as the case may be the board of managers, should determine that extraordinary
political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances;
such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified
to any interested parties by the manager or as the case may be the board of managers.
Art. 5. Share capital. The issued share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euros (EUR
12,500) represented by five hundred (500) shares with a nominal value of twenty-five Euros (EUR 25) each. The capital
of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for
amendment of these articles of association and the Company may proceed to the repurchase of its other shares upon
resolution of its shareholders.
Any available share premium shall be distributable.
Art. 6. Transfer of Shares. Shares are freely transferable among shareholders. Except if otherwise provided by law, the
share transfer to non-shareholders is subject to the consent of shareholders representing at least seventy-five per cent
(75%) of the Company's share capital.
Art. 7. Management of the Company. The Company is managed by one or several managers who do not need to be
shareholders.
The sole manager or as the case may be, the board of managers, is vested with the broadest powers to manage the
business of the Company and to authorise and/or perform all acts of disposal and administration falling within the purposes
of the Company. All powers not expressly reserved by the law or by the articles of association to the general meeting
shall be within the competence of the sole manager or as the case may be, the board of managers.
Vis-à-vis third parties the sole manager or as the case may be, the board of managers, has the most extensive powers
to act on behalf of the Company in all circumstances and to do, authorise and approve all acts and operations relative to
the Company and not reserved by law or these articles of association to the general meeting of shareholders.
The managers are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of share-
holders, which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed
for an undetermined period. The managers may be re-elected but their appointment may also be revoked with or without
cause (ad nutum) at any time.
In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. Any manager may participate in
any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the
persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also at
any time be held by conference call or similar means only. The participation in, or the holding of, a meeting by these
means is equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be
represented at meetings of the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager
may accept and vote.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours (24) at
least in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
121044
L
U X E M B O U R G
motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by cable, telegram, telex, e-mail or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening
notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted
by the board of managers.
Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company.
The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman of that meeting or, in its absence,
by any two managers. Copies or excerpts of such minutes shall be signed by the chairman of that meeting or by any two
managers.
The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means
when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety
will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including circular
resolutions, may be conclusively certified or an extract thereof may be issued under the individual signature of any
manager.
The Company will be bound by the sole signature in the case of a sole manager, and in the case of a board of managers
by the sole signature of anyone of the managers. In any event the Company will be validly bound by the sole signature of
any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by the sole manager (if there is only
one) or as the case may be the board of managers or anyone of the managers.
Art. 8. Liability of the Managers. The manager(s) are not held personally liable for the indebtedness of the Company.
As agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties.
Subject to the exceptions and limitations listed below, every person who is, or has been, a manager or officer of the
Company shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against all
expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding which he becomes
involved as a party or otherwise by virtue of his being or having been such manager or officer and against amounts paid
or incurred by him in the settlement thereof. The words "claim", "action", "suit" or "proceeding" shall apply to all claims,
actions, suits or proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words "liability"
and "expenses" shall include without limitation attorneys' fees, costs, judgements, amounts paid in settlement and other
liabilities.
No indemnification shall be provided to any manager or officer:
(i) against any liability to the Company or its shareholders by reason of wilful misfeasance, bad faith, gross negligence
or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office;
(ii) with respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated to have acted in bad faith and not in
the interest of the Company; or
(iii) in the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of competent jurisdiction or by
the board of managers.
The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any manager
or officer may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such manager or officer
and shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein shall
affect any rights to indemnification to which corporate personnel, including directors and officers, may be entitled by
contract or otherwise under law.
Expenses in connection with the preparation and representation of a defence of any claim, action, suit or proceeding
of the character described in this article shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof upon receipt
of any undertaking by or on behalf of the officer or director, to repay such amount if it is ultimately determined that he
is not entitled to indemnification under this article.
Art. 9. Shareholder voting rights. Each shareholder may take part in collective decisions. He has a number of votes
equal to the number of shares he owns and may validly act at any meeting of shareholders through a special proxy.
Art. 10. Shareholder meetings. Decisions by shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as pre-
scribed by Luxembourg Company law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings. Any regularly constituted
meeting of shareholders of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the entire
body of shareholders of the Company.
Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to shareholders to their address appearing
in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire
share capital of the Company is represented at a meeting, the meeting may be held without prior notice.
In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the shareholders at their addresses
inscribed in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days before the proposed effective date
of the resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for
collective decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous
written resolution may be passed at any time without prior notice.
121045
L
U X E M B O U R G
Except as otherwise provided for by law, (i) decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by
shareholders representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting or
first written resolution, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions
shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented. (ii) However, decisions
concerning the amendment of the articles of association are taken by (x) a majority of the shareholders (y) representing
at least three quarters of the issued share capital and (iii) decisions to change of nationality of the Company are to be
taken by Shareholders representing one hundred percent (100%) of the issued share capital.
At no time shall the Company have more than thirty (30) shareholders. At no time shall an individual be allowed to
become a shareholder of the Company.
Art. 11. Accounting Year. The accounting year begins on 1
st
January of each year and ends on 31
st
December of the
same year save for the first accounting year which shall commence on the day of incorporation and end on 31
st
December
2014.
Art. 12. Financial Statements. Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the
manager or, as the case may be, the board of managers.
The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.
Art. 13. Distributions. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction
ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.
The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the manager,
or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood
that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by
profits carried forward and distributable reserves and premium but decreased by losses carried forward and sums to be
allocated to a reserve to be established by law.
The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal
reserve account.
Art. 14. Dissolution. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators
who may be but do not need to be shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders who will
specify their powers and remunerations.
Art. 15. Sole Shareholder. If, and as long as one shareholder holds all the shares of the Company, the Company shall
exist as a single shareholder company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10
th
August 1915 on commercial com-
panies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.
Art. 16. Applicable law. For anything not dealt with in the present articles of association, the shareholders refer to the
relevant legislation.
<i>Subscription and paymenti>
The articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the appearing party has
subscribed and entirely paid-up the following shares:
Subscriber
Number
of shares
Subscription
price (EUR)
BRE/Europe 7Q S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 EUR 12,500
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 EUR 12,500
Evidence of the payment of the total subscription price has been shown to the undersigned notary.
<i>Expenses, Valuationi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately EUR 1,500.-
<i>Extraordinary general meetingi>
The sole shareholder has forthwith taken immediately the following resolutions:
1. The registered office of the Company is fixed at: 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
2. The following person is appointed manager of the Company for an undetermined period of time subject to the
articles of association of the Company with such signature powers as set forth in the articles of association of the Company:
- BRE/Management 7 S.A., a société anonyme incorporated under the laws of Luxembourg, with registered office at
2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg and being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in
Luxembourg under number B 180.304.
121046
L
U X E M B O U R G
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg on the day before mentioned.
The document having been read to the appearing party, who requested that the deed should be documented in English,
the said appearing party signed the present original deed together with the notary, having personal knowledge of the
English language. The present deed, worded in English, is followed by a translation into German. In case of divergences
between the English and the German text, the English version will prevail.
The document having been read to the appearing party, known to the notary by its name, first name, civil status and
residence, the said appearing party signed together with the notary the present deed.
Folgt die Deutsche Übersetzung des Vorstehenden textes:
Im Jahre zweitausend vierzehn, am zehnten Juli.
Vor dem unterzeichnenden Notar Maître Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg.
Ist erschienen,
BRE/Europe 7Q S.à r.l., eine société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) luxemburgischen
Rechts mit Sitz in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, deren Gesellschaftskapital zwölftausend fünf hundert Euro
(EUR 12.500) beträgt, und eingetragen ist im Registre de commerce et des sociétés in Luxemburg unter der Nummer B
180.323,
hier vertreten durch Frau Flora Verrecchia, Rechtsanwältin, beruflich wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer privat-
schriftlichen Vollmacht welche vorliegender Urkunde beigefügt ist um mit dieser bei der Registrierungsbehörde einge-
reicht zu werden.
Die erschienene Partei hat in ihrer vorgenannten Eigenschaft den unterzeichnenden Notar ersucht, die Gründungs-
satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) "Chameleon Topco S.à r.l." wie
folgt zu beurkunden.
Art. 1. Gesellschaftsname. Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen
"Chameleon Topco S.à r.l." (die "Gesellschaft") wird hiermit von der erschienenen Partei und allen Personen, die gege-
benenfalls zukünftig als Gesellschafter eintreten, gegründet. Die Gesellschaft wird durch vorliegende Satzung und durch
die entsprechende luxemburgische Gesetzgebung geregelt.
Art. 2. Gesellschaftszweck. Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen in jeder beliebigen Form an in-
und ausländischen Gesellschaften sowie jede andere Form von Investitionen, sowie den Erwerb durch Kauf, Zeichnung
oder andere Art und Weise wie Übertragung durch Verkauf oder Tausch von Finanzinstrumenten jeder Art und die
Verwaltung, Aufsicht und Entwicklung ihres Portfolios.
Die Gesellschaft kann ebenfalls alle Transaktionen welche sich auf direkten oder indirekten Erwerb von Grundbesitz,
Eigentum, und Grundbesitzrechte in Luxemburg oder im Ausland oder auf den Erwerb von Beteiligungen an Unternehmen
welche im Besitz von Grundrechten sind oder von Unternehmensbeteiligungen jedweder Form beziehen, durchführen
sowie die Verwaltung, Aufsicht und Entwicklung dieser Beteiligungen und dieses Vermögen ausführen.
Die Gesellschaft kann Bürgschaften geben, Sicherheiten leisten, Darlehen ausgeben oder die Gesellschaften an denen
die Gesellschaft direkte oder indirekte Beteiligungen besitzt oder die zur Gruppe von Gesellschaften gehört, der die
Gesellschaft angehört, in jeder anderen Form unterstützen.
Die Gesellschaft kann außerdem in jeder beliebigen Form Darlehen erwerben, auch mit Preisnachlass, Darlehen ver-
geben, Kapital verleihen, sowie Vorschüsse gewährleisten oder unter jeglichen Konditionen Kredite vergeben, einschließ-
lich und ohne Einschränkungen derer Kredite, in Bezug auf ein Immobilien-Unternehmen oder -Unterfangen, die sich von
jeglichen Kreditaufnahmen der Gesellschaft oder von der Ausgabe von Kapital oder Schuldtitel jeglicher Art an alle Per-
sonen und Unternehmen, für die es für richtig empfunden wurde, ergeben. Die Gesellschaft kann Swaps, Futures,
Forwards, derivative Instrumente, Optionen, Rückkäufe, Wertpapierverleihe und ähnliche Transaktionen abschließen und
unbeschadet der Allgemeingültigkeit des Vorstehenden, jegliche Methode und Instrumente im Zusammenhang mit ihren
Immobiliengeschäften einsetzen. Die Gesellschaft kann auch jegliche Verträge über Garantien, Entschädigungen, Sicher-
heiten und alle weiteren äquivalente Verträge abschließen, so dass der Nutzen der, im Rahmen solcher Immobilienge-
schäfte vergebenen, Garantien und/oder Sicherheiten ihr zu Gute kommen kann. Die Gesellschaft kann im Rahmen solcher
Immobiliengeschäfte jegliche erforderliche Rolle übernehmen, einschließlich und ohne Einschränkungen der Rolle des
Arranger, lead Manager, Facility Agent, Security Agent, Documentation Agent. Die Gesellschaft wird die Tätigkeit der
Immobilienfinanzierung oder des Immobilienkrediterwerbs nicht in einer Weise ausüben, die eine Regulierung erfordern
würde gemäß der geänderten Fassung des Gesetzes des 5. Aprils 1993 bezüglich des Finanzsektors oder jeglichen zu-
künftigen Gesetzes oder Regulierungsmaßnahme, die dieses Gesetz abändern oder ersetzen sollte.
Die Gesellschaft kann alle geschäftlichen, technischen, finanziellen ebenso wie alle andere direkt oder indirekt ver-
bundenen Tätigkeiten welche die Erfüllung des Geschäftszwecks in den oben genannten Bereichen erleichtern, vorneh-
men.
Unter anderem wird die Gesellschaft allen Gesellschaften ihres Portfolios die für die Verwaltung, Entwicklung und
Aufsicht dieser Gesellschaften notwendigen Leistungen zur Verfügung stellen. Für diesen Zweck kann die Gesellschaft die
Unterstützung anderer Berater beanspruchen und auf solche zurückgreifen.
121047
L
U X E M B O U R G
Art. 3. Geschäftsdauer. Die Gesellschaft ist auf unbegrenzte Dauer gegründet
Art. 4. Gesellschaftssitz. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg. Dieser kann,
durch Beschluss einer außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter die sich, in der für die Abänderung der
Satzung vorgesehenen Art und Weise beraten, an jeden Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.
Der eingetragene Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss des Geschäftsführers, beziehungsweise durch die Ge-
schäftsführung innerhalb der Gemeinde verlegt werden.
Die Gesellschaft kann Geschäfts- und Zweigstellen in Luxemburg und im Ausland errichten.
Sollte der Geschäftsführer, oder im Falle einer Geschäftsführung die Geschäftsführung, feststellen, dass außerordent-
liche politische, wirtschaftliche oder soziale Ereignisse eingetreten sind oder unmittelbar bevorstehen welche die
normalen Tätigkeiten der Gesellschaft an ihrem eingetragenen Sitz oder die problemlose Kommunikation zwischen die-
sem Sitz und Personen im Ausland beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zum
vollständigen Ende solcher ungewöhnlichen Umstände ins Ausland verlegt werden; derartige vorläufige Maßnahmen haben
keine Auswirkung auf die staatliche Zugehörigkeit der Gesellschaft, die unbeschadet einer solchen vorübergehenden
Sitzverlegung eine luxemburgische Gesellschaft bleibt. Solche vorübergehenden Maßnahmen werden vom Geschäftsführer
oder, im Falle einer Geschäftsführung, von der Geschäftsführung vorgenommen und jeglichen betroffenen Personen mit-
geteilt.
Art. 5. Gesellschaftskapital. Das ausgegebene Gesellschaftskapital der Gesellschaft beläuft sich auf zwölftausend fünf
hundert Euro (EUR 12.500), eingeteilt in fünf hundert (500) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je fünf und
zwanzig Euro (EUR 25).
Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter in der für die Abänderung der
Satzung vorgesehenen Art und Weise erhöht oder verringert werden und die Gesellschaft kann seine anderen Gesell-
schaftsanteile durch Beschluss der Gesellschafter zurückkaufen.
Verfügbare Anteilsprämien können verteilt werden.
Art. 6. Übertragung der Anteile. Die Anteile sind unter den Gesellschaftern frei übertragbar. Soweit es das Gesetz
nicht anders bestimmt, bedarf die Übertragung von Anteilen auf Dritte der Einwilligung von Gesellschaftern, welche
zusammen mindestens fünfundsiebzig Prozent (75%) des Gesellschaftskapitals halten.
Art. 7. Geschäftsführung. Die Geschäftsführung der Gesellschaft erfolgt durch einen oder mehrere Geschäftsführer
die keine Gesellschafter sein müssen.
Der alleinige Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung ist mit den weitestreichenden Befugnissen aus-
gestattet, das Geschäft der Gesellschaft zu verwalten und ist dazu befugt, jede Handlungen und Tätigkeiten, die mit dem
Gegenstand der Gesellschaft im Einklang stehen, zu genehmigen und/oder auszuführen. Sämtliche Befugnisse, die nicht
ausdrücklich per Gesetz oder durch die vorliegende Satzung den Gesellschaftern vorbehalten sind, fallen in den Zustän-
digkeitsbereich des Geschäftsführers beziehungsweise der Geschäftsführung.
Gegenüber Dritten hat der Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung die weitestreichenden Befugnisse
um in allen Umständen, im Namen und Auftrag der Gesellschaft zu handeln und in jeden Umständen, jeden Akt und jede
Handlung, welche nicht durch die vorliegende Satzung oder durch die entsprechende luxemburgische Gesetzgebung im
Kompetenzbereich der Gesellschafterversammlung liegt, im Auftrag der Gesellschaft vorzunehmen, zu erlauben und gut-
zuheißen.
Die Geschäftsführer werden durch mehrheitlichen Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter gewählt und
abberufen, welche ihre Befugnisse und die Amtsdauer beschließt. Wenn keine Frist gesetzt wird, dann sind die Geschäfts-
führer auf unbestimmte Zeit ernannt. Die Geschäftsführer können wiedergewählt werden, jedoch kann ihre Ernennung
zu jeder Zeit mit oder ohne Grund (ad nutum) widerrufen werden.
Im Falle mehrerer Geschäftsführer bilden diese die Geschäftsführung. Jeder Geschäftsführer kann an jeder Sitzung der
Geschäftsführung teilnehmen mittels Telefonkonferenz oder anderen zur Verfügung stehenden Kommunikationsmitteln
insofern gewährleistet ist, dass alle an der Sitzung teilnehmenden Personen sich hören und miteinander kommunizieren
können. Eine Sitzung kann jederzeit mittels einer Telefonkonferenz oder ähnlichen Kommunikationsmitteln abgehalten
werden. Die Teilnahme oder das Abhalten einer Sitzung mit Hilfe dieser Mittel entspricht einer persönlichen Teilnahme
an der betroffenen Sitzung. Die Geschäftsführer können sich in den Sitzungen ohne Einschränkung der Anzahl der Voll-
machten durch einen anderen Geschäftsführer, der hierzu bevollmächtigt ist, vertreten lassen.
Die Geschäftsführer sind mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor Beginn einer Sitzung der Geschäftsführung
mittels schriftlicher Einberufung, zu benachrichtigen, außer in Notfällen, in welchem Fall die Art und die Gründe dieser
Umstände in der Einberufung erläutert werden müssen. Auf das Recht auf die oben beschriebene Weise einberufen zu
werden kann jeder Geschäftsführer durch schriftliche Zustimmung per Telegramm, Telekopie, Email, Telefax oder per
ähnlichem Kommunikationsmittel verzichten. Spezifische Einberufungen sind nicht notwendig für Sitzungen, welche vorher
zu einem durch Geschäftsführungsbeschluss genehmigten Zeitplan und zu vorgesehenen Zeiten und an vorbestimmten
Orten abgehalten werden.
Entscheidungen der Geschäftsführung werden durch die Mehrheit der Geschäftsführer der Gesellschaft gefasst.
121048
L
U X E M B O U R G
Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden der Sitzung oder, in seiner Abwesenheit,
von zwei Geschäftsführern unterzeichnet.
Die Kopien oder Auszüge der Protokolle werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet.
Schriftliche Beschlüsse der Geschäftsführung können, aus einem einzigen oder mehreren einzelnen Dokumenten, gültig
abgeschlossen werden, wenn sie von allen Mitgliedern der Geschäftsführung schriftlich, per Telegramm, Telefax oder per
ähnlichem Kommunikationsmittel genehmigt wurden. Die verschiedenen Dokumente gleichen Inhalts bilden zusammen
einen gültigen schriftlichen Beschluss. Beschlüsse der Geschäftsführung, einschließlich schriftliche Beschlüsse, können von
einem einzelnen Geschäftsführer beweiskräftig beglaubigt und ein Auszug davon beweiskräftig unterschrieben werden.
Die Gesellschaft wird durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers und durch die Unterschrift eines einzelnen
Geschäftsführers im Falle einer Geschäftsführung gebunden. Die Gesellschaft ist in jedem Fall wirksam durch die Unter-
schrift einer oder mehrerer hierzu durch den alleinigen Geschäftsführer, beziehungsweise durch die Geschäftsführung
oder einer der Geschäftsführer, bevollmächtigten Personen, gebunden.
Art. 8. Haftung der Geschäftsführung. Die Geschäftsführer sind für Verschuldung der Gesellschaft nicht persönlich
haftbar. Als Vertreter der Gesellschaft sind sie jedoch für die Ausführung ihrer Aufgaben und Pflichten verantwortlich.
Vorbehaltlich den unten aufgeführten Ausnahmen und Beschränkungen, wird jede Person, die ein Geschäftsführer oder
leitender Angestellter der Gesellschaft ist oder war, von der Gesellschaft in vollem, gesetzlich erlaubten, Umfang gegen
Verbindlichkeiten und gegen alle Ausgaben, welche üblicherweise entstanden sind oder von ihm gezahlt wurden in Ver-
bindung mit Klagen, Prozessen oder Verfahren in die er als Partei oder anderweitig eintritt aufgrund dessen, dass er ein
Geschäftsführer oder leitender Angestellter ist oder gewesen ist und die diesbezüglich gezahlten Beträge oder von durch
deren Beilegung entstandenen Beträge, schadlos gehalten werden. Die Begriffe „Klage“, „Streitsache“, „Prozess“ oder
„Verfahren“ finden auf alle anhängigen oder bevorstehenden Klagen, Streitsachen, Prozesse oder Verfahren Anwendung
(zivilrechtlich, strafrechtlich oder sonstige, einschließlich Rechtsmittel) Anwendung und die Begriffe „Verbindlichkeit“ und
„Ausgaben“ beinhalten ohne Beschränkung Anwaltskosten, Prozesskosten, Sicherheitsleistungen, gezahlte Beträge bei
Streitbeilegung und andere Verbindlichkeiten.
Einem Geschäftsführer oder leitendem Angestellten wird keine Schadloshaltung gewährt:
(i) gegen Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschaft oder ihrer Gesellschafter, aufgrund von vorsätzlich begangenen
unerlaubten Handlungen, Bösgläubigkeit, grober Fahrlässigkeit oder rücksichtsloser Missachtung der Aufgaben, die in
seiner Amtsführung enthalten sind;
(ii) im Zusammenhang mit jeglichen Verfahren bei welchen er wegen bösgläubigem und nicht im Interesse der Gesell-
schaft erfolgtem Handeln, verurteilt wurde; oder
(iii) im Falle einer Beilegung, es sei denn die Beilegung ist von einem Gericht unter zuständiger Gerichtsbarkeit oder
von der Geschäftsführung genehmigt worden.
Das Recht der Schadloshaltung, das hier vorgesehen ist, ist abtrennbar und berührt keine anderen Rechte auf die das
Verwaltungsratsmitglied oder der leitende Angestellte jetzt oder später ein Anrecht hat, und soll fortgeführt werden in
der Person, die aufgehört hat, ein Geschäftsführer oder leitender Angestellter zu sein und soll dem Vorteil der Erben,
Testamentsvollstreckern und Verwaltern einer solchen Person dienen. Nichts hierin Enthaltenes berührt die Rechte zur
Schadloshaltung, auf die Gesellschaftspersonal, eingeschlossen Geschäftsführer und leitende Angestellte, aufgrund von
Vertrag oder anderweitig durch Gesetz, Anspruch haben könnten.
Ausgaben in Verbindung mit Vorbereitung und Vertretung der Verteidigung einer Klage, Streitsache, Prozess oder
Verfahren beschrieben in diesem Artikel, soll von der Gesellschaft vor der endgültigen Verfügung darüber bei Zugang
jeglicher Unternehmung seitens oder im Namen eines leitenden Angestellten oder Geschäftsführers vorgestreckt werden,
um den benannten Betrag zurückzuzahlen wenn es letztlich bestimmt ist, dass er keinen Anspruch auf Schadloshaltung
unter diesem Artikel hat.
Art. 9. Stimmrechte der Gesellschafter. Jeder Gesellschafter kann an kollektiven Entscheidungen teilnehmen. Die Zahl
seiner Stimmen entspricht der Zahl seiner Gesellschaftsanteile und der Gesellschafter kann bei jeder Versammlung durch
eine spezielle Vollmacht vertreten werden.
Art. 10. Gesellschafterversammlungen. Die Beschlüsse der Gesellschafter werden in der im luxemburgischen Gesell-
schaftsrecht vorgeschriebenen Form und mit der darin vorgesehenen Mehrheit, schriftlich (soweit dies gesetzlich möglich
ist) oder in Gesellschafterversammlungen, gefasst. Jede ordnungsgemäß konstituierte Gesellschafterversammlung der
Gesellschaft beziehungsweise jeder ordnungsgemäß schriftlicher Beschluss vertritt die Gesamtheit der Gesellschafter der
Gesellschaft.
Die Einberufung der Versammlungen durch den Geschäftsführer/die Geschäftsführung hat mindestens acht (8) Tage
vor der Versammlung mittels eingeschriebenen Briefes an die Gesellschafter an ihre im Anteilsregister der Gesellschaft
eingetragene Adresse, zu erfolgen. Wenn das gesamte Gesellschaftskapital der Gesellschaft vertreten ist, kann die Sitzung
ohne vorherige Einberufung abgehalten werden.
Werden Beschlüsse im Wege eines Zirkularbeschlusses der Gesellschafter gefasst, so wird der Inhalt des Beschlusses
mindestens acht (8) Tage bevor der Beschluss wirksam werden soll, an alle Gesellschafter an ihre im Anteilsregister
eingeschriebene Adresse mittels eingeschriebenen Briefs übersandt. Die Beschlüsse werden wirksam bei Zustimmung
121049
L
U X E M B O U R G
der vom Gesetz vorgesehenen Mehrheiten für gemeinsame Entscheidungen (oder, unter der Voraussetzung der Befrie-
digung der Mehrheitsvoraussetzungen, am in dieser Entscheidung festgelegten Tag). Einstimmige Zirkularbeschlüsse
können jederzeit ohne vorherige Ankündigung getroffen werden.
Soweit gesetzlich nichts anderes vorgesehen ist, (i) werden die in den Gesellschafterversammlungen zu fassenden
Beschlüsse von den Gesellschaftern getroffen, welche mehr als die Hälfte des Geschäftskapitals vertreten. Wird eine
solche Mehrheit bei der ersten Gesellschafterversammlung nicht erreicht, werden die Gesellschafter per Einschreiben zu
einer zweiten Gesellschafterversammlung geladen und die Beschlüsse werden sodann aufgrund der Mehrheit der abge-
gebenen Stimmen gefasst, unbeschadet der Anzahl der vertretenen Geschäftsanteile. (ii) Die Satzung kann jedoch nur mit
Zustimmung (x) der Mehrheit der Gesellschafter, welche (y) zwei Drittel des Gesellschaftskapitals vertreten, abgeändert
werden und (iii) Entscheidungen, die Nationalität der Gesellschaft zu ändern, bedürfen der Zustimmung von Gesellschaf-
tern, die einhundert Prozent (100%) des Gesellschaftskapitals vertreten.
Zu keiner Zeit soll die Gesellschaft mehr als dreißig (30) Gesellschafter haben. Zu keiner Zeit soll es einer natürlichen
Person gestattet sein, ein Gesellschafter der Gesellschaft zu werden.
Art. 11. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten (1.) Januar und endet am einunddreißigsten (31.) Dezember
eines jeden Jahres. Das erste Geschäftsjahr, welches am Tage der Gründung der Gesellschaft beginnt, wird am 31. De-
zember 2014 enden.
Art. 12. Jahresabschluss. Der alleinige Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung erstellt jedes Jahr die
Jahresabrechnung der Gesellschaft.
Jeder Gesellschafter kann die Jahresabrechnung am Sitz der Gesellschaft einsehen.
Art. 13. Gewinnverwendung. Fünf Prozent (5%) des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft werden der gesetzlich
vorgeschriebenen Rücklage zugeführt. Diese Rücklageeinzahlungspflicht besteht nicht mehr, sobald die gesetzliche Rück-
lage zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.
Die Gesellschafter können auf der Grundlage eines von dem alleinigen Geschäftsführer, beziehungsweise der Ge-
schäftsführung angefertigten Zwischenabschlusses die Ausschüttung von Abschlagsdividenden beschließen, sofern dieser
Zwischenabschluss zeigt, dass ausreichend Gewinne und andere Reserven zur Ausschüttung zur Verfügung stehen, wobei
der auszuschüttende Betrag die seit dem Ende des vorhergehenden Geschäftsjahres erzielten Gewinne, für welches die
Jahresabschlüsse bereits bewilligt wurden, erhöht um die vorgetragenen Gewinne und ausschüttbaren Rücklagen, ver-
mindert um die vorgetragenen Verluste und die der gesetzlichen Rücklage zuzuführenden Beträge, nicht übersteigen darf.
Der Saldo kann nach Entscheidung der Gesellschafterversammlung an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.
Das Anteilsprämienkonto kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung an die Gesellschafter ausgeschüttet
werden. Die Gesellschafterversammlung kann beschließen, jeden Betrag vom Anteilsprämienkonto auf die gesetzliche
Rücklage zu übertragen.
Art. 14. Auflösung. Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft ernennen die Gesellschafter einen oder mehrere Liqui-
datoren, bei welchen es sich nicht um Gesellschafter handeln muss, zwecks der Durchführung der Auflösung und
bestimmen ihre Befugnisse und Vergütung.
Art. 15. Alleingesellschafter. Sofern nur ein Gesellschafter alle Geschäftsanteile der Gesellschaft hält, gilt Artikel 179
(2) des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften und die Artikel 200-1 und 200-2 finden u.a. Anwendung.
Art. 16. Anwendbares Recht. Sämtliche nicht ausdrücklich durch diese Satzung geregelten Angelegenheiten richten
sich nach den entsprechenden Regelungen des anwendbaren Gesetzes.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Nach dem die erschienene Partei die Gründungssatzung erstellt hat, hat sie das gesamte Gesellschaftskapital wie folgt
eingezahlt und gezeichnet:
Einzahler
Zahl der
Geschäftsanteile
Einzahlungspreis
(EUR)
BRE/Europe 7Q S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
EUR 12.500
Summe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
EUR 12.500
Ein Beleg für die vollständige Einzahlung der Geschäftsanteile wurde dem unterzeichneten Notar vorgelegt.
<i>Kosteni>
Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund der vorlie-
genden Gesellschaftsgründung entstehen, werden auf ungefähr EUR 1.500,- geschätzt.
<i>Außerordentliche Beschlüsse des Gesellschaftersi>
Unverzüglich nach der Gründung der Gesellschaft hat der Alleinige Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:
1. Sitz der Gesellschaft ist in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg.
121050
L
U X E M B O U R G
2. Die folgende Person wird für einen unbeschränkten Zeitraum zum Geschäftsführer der Gesellschaft mit der in der
Satzung der Gesellschaft beschriebenen Unterschriftsbefugnis ernannt:
- BRE/Management 7 S.A., eine Aktiengesellschaft (société anonyme) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 2-4, rue
Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg und eingetragen im Registre de Commerce et des Sociétés in Luxemburg unter der
Nummer B 180.304.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnende Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass auf Ersuchen der oben erschie-
nenen Partei, die vorliegende Urkunde in English abgefasst wird, gefolgt von einer deutschen Übersetzung.
Auf Ersuchen derselben erschienenen Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deut-
schen Text, ist die englische Fassung maßgebend.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die erschienene Partei die dem amtierenden Notar nach
Namen, Vornamen, Zivilstand und Wohnort bekannt, hat dieselbe zusammen mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.
Gezeichnet: F. VERRECCHIA und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 15 juillet 2014. Relation: LAC/2014/33133. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri>
(signé): I. THILL.
- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - Der Gesellschaft auf Begehr erteilt.
Luxemburg, den 17. Juli 2014.
Référence de publication: 2014104733/452.
(140125406) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2014.
CLSec 1 Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 610.003,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5C, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 184.304.
In the year two thousand and fourteen, on the ninth day of July.
Before Maître Francis KESSELER, notary public established in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
CLSec Holdings 1 Limited, a limited company formed and existing under the laws of Bermuda, registered with the
Registrar of Companies of Bermuda under number 48609, and having its registered office at Codan Dervices Limited of
Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, HM 11, Bermuda (the “Sole Shareholder” or the “Contributor”),
hereby represented by Mrs. Claudia Rouckert, private employee, with professional address at 5, rue Zénon Bernard,
L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.
Such proxy having been initialled “ne varietur” by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to this deed to be filed with such deed with the registration authorities.
The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record as follows:
I.- The appearing party is the sole shareholder of CLSec 1 Lux S.à r.l., a société à responsabilité limitée, existing under
the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office located at 5c, rue Eugène Ruppert, L-2453
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre
de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) under number B 184.304 incorporated by a deed enacted by notary Maître
Blanche MOUTRIER, on 17 January 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 894
page 42879 (the “Company”). The articles of association of the Company have been amended for the last time on 27
June 2014 by a deed enacted by the undersigned notary.
II.- That the 590,002 (five hundred ninety thousand two) shares each with a nominal value of USD 1 (one United States
Dollar), representing the entire share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on
all items on the agenda of which the Sole Shareholder expressly states having been duly informed about beforehand.
III.- The agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Waiving of notice right;
2. Increase of the share capital of the Company by an amount of USD 20,001 (twenty thousand one United States
Dollars) so as to raise it from its current amount of USD 590,002 (five hundred ninety thousand two United States
Dollars) to USD 610,003 (six hundred ten thousand three United States Dollars) by the issuance of 20,001 (twenty
thousand one) new shares with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar);
3. Subscription and payment by Clsec Holdings 1 Limited of the new shares by way of contribution in kind;
121051
L
U X E M B O U R G
4. New composition of the shareholding of the Company;
5. Subsequent amendment of the first paragraph of article 8 of the articles of association of the Company; and
6. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolutions have been taken:
<i>First resolution:i>
It is resolved that the Sole Shareholder waives its right to the prior notice of the current meeting; the Sole Shareholder
acknowledges being sufficiently informed on the agenda and considers being validly convened and therefore agrees to
deliberate and vote upon all the items on the agenda. It is further resolved that all the relevant documentation has been
put at the disposal of the Sole Shareholder within a sufficient period of time in order to allow it to examine carefully each
document.
<i>Second resolution:i>
It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of USD 20,001 (twenty thousand one United
States Dollars) so as to raise it from its current amount of USD 590,002 (five hundred ninety thousand two United States
Dollars) to USD 610,003 (six hundred ten thousand three United States Dollars) by the issuance of 20,001 (twenty
thousand one) new shares with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) (the “New Shares”), the whole to
be fully paid up through contribution in kind consisting in:
- 20,000 (twenty thousand) shares having a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) of Aircraft Solutions
Lux XX S.à r.l., a "société à responsabilité limitée" existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its
registered office located at 5c, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with
the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) under number B
186.862;
- 1 (one) ordinary share having a face value of USD 1 (one United States Dollar) of AS 777-2012 (Offshore) Limited
Bermuda, an exempted company having its registered office located at Bermuda (the “Contribution”).
<i>Contributor's Intervention - Subscription - Paymenti>
Thereupon intervenes the Contributor represented as stated here above. The Contributor declares to subscribe the
New Shares and to pay them up entirely by the Contribution.
<i>Third resolution:i>
It is resolved to accept the subscription and the payment by the Contributor of the New Shares through the Contri-
bution.
<i>Valuationi>
The valuation of USD 20,001 (twenty thousand one United States Dollars) has been approved by the managers of the
Company pursuant to a statement of contribution value effective as of 9 July 2014, which shall remain attached to this
deed to be filed with such deed with the registration authorities.
<i>Evidence of the Contribution’s existencei>
A proof of the Contribution has been given to the Company.
<i>Managers’ interventioni>
Thereupon intervene:
a) Mr. Pedro Fernandes das Neves, as manager, with professional address at 5c, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxem-
bourg, Grand Duchy of Luxembourg;
b) Mrs. Julie K. Braun, as manager, with professional address at 4600 Wells Fargo Center, 90 So 7
th
Street, Minneapolis,
United States of America, MN 55402, and
c) Mrs. Virginia Strelen, as independent manager, with professional address 15, rue Edward Steichen, 4
th
Floor, L-1540
Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,
all represented here by Mrs. Claudia Rouckert, prenamed, by virtue of a proxy contained in a statement of contribution
value.
Acknowledging having been previously informed of the extent of their responsibility, legally bound as managers of the
Company by reason of the Contribution, expressly agree with the description of the Contribution, with their valuation,
and confirm the validity of the subscription and payment.
<i>Fourth resolution:i>
As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the shareholding of the Company is now composed as
follows:
121052
L
U X E M B O U R G
Clsec Holdings 1 Limited: 610,003 (six hundred ten thousand three) shares each with a nominal value of USD 1 (one
United States Dollar).
The notary acts that all the 610,003 (six hundred ten thousand three) shares mentioned above, representing the entire
share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on the resolution to be taken below.
<i>Fifth resolution:i>
As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the Contribution having been fully carried out, it
is resolved to amend the first paragraph of article 8 of the Company’s articles of association so that it shall now read as
follows:
“ Art. 8. The Company’s share capital is set at USD 610,003 (six hundred ten thousand three United States Dollars),
represented by 610,003 (six hundred ten thousand three) shares, each with a nominal value of USD 1 (one United States
Dollar).”
No other amendment is to be made to this article.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon closed.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Esch-sur-Alzette on the day named at the beginning of this
document.
The document having been read to the person appearing, she signed together with us, the notary, the present original
deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version shall prevail.
Traduction française du texte qui précède
L’an deux mille quatorze, le neuvième jour du mois de juillet.
Par-devant Maître Francis KESSELER, notaire établi à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
A comparu:
CLSec Holdings 1 Limited, une limited company constituée et existant sous la loi des Bermudes, enregistrée au Registre
des Sociétés des Bermudes sous le numéro 48609, et ayant son siège social sis à Codan Dervices Limited of Clarendon
House, 2 Church Street, Hamilton, HM 11, Bermudes (l’"Associé Unique" ou l’"Apporteur"),
ici représenté par Mme Claudia Rouckert, employée privée, établie professionnellement au 5, rue Zénon Bernard,
L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé.
Ladite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire agissant au nom des parties comparantes
et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte pour être soumises avec celui-ci aux formalités de
l’enregistrement.
La partie comparante, représentée telle que décrit ci-dessus, a requis du notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. La partie comparante est l’associé unique de CLSec 1 Lux S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et
existant selon les lois du Luxembourg, ayant son siège social au 5c, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
184.304 constituée suivant acte reçu par le notaire Maître Blanche MOUTRIER, le 17 janvier 2014, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 894 page 42879 (la «Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés
pour la dernière fois le 27 juin 2014, selon un acte notarié du notaire instrumentaire.
II.- Que les 590.002 (cinq cent quatre-vingt-dix mille et deux) parts sociales d’une valeur nominale de 1 USD (un Dollar
américain) chacune, représentant la totalité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l’assemblée
peut valablement se prononcer sur tous les points de l’ordre du jour desquels l’Associé Unique reconnait expressément
avoir été dûment préalablement informé.
III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Renonciation au droit de convocation;
2. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de 20.001 USD (vingt mille un Dollars américains) afin
de le porter de son montant actuel de 590.002 USD (cinq cent quatre-vingt-dix mille deux Dollars américains) à 610.003
USD (six cent dix mille trois Dollars américains) par l’émission de 20.001 (vingt mille un) nouvelles parts sociales d’une
valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain) chacune;
3. Souscription et paiement par Clsec Holdings 1 Limited de la nouvelle part sociale par voie d’un apport en nature;
4. Nouvelle composition de l’actionnariat de la Société;
5. Modification subséquente du premier paragraphe de l’article 8 des statuts de la Société; et
6. Divers.
121053
L
U X E M B O U R G
Suite à l’approbation de ce qui précède par l’Associé Unique, les résolutions suivantes ont été adoptées:
<i>Première résolution:i>
Il est décidé que l’Associé Unique renonce à son droit de recevoir la convocation préalable afférente à la présente
assemblée, reconnaît avoir été suffisamment informé de l’ordre du jour, et considère avoir été valablement convoqué et
en conséquence accepte de délibérer et voter sur tous les points figurant à l’ordre du jour. Il est en outre décidé que
toute la documentation produite lors de cette assemblée a été mise à la disposition de l’Associé Unique dans un délai
suffisant afin de lui permettre un examen attentif de chaque document.
<i>Deuxième résolution:i>
Il est décidé d’augmenter le capital social de la Société d'un montant de 20.001 USD (vingt mille un Dollars américains)
afin de le porter de son montant actuel de 590.002 USD (cinq cent quatre-vingt-dix mille deux Dollars américains) à
610.003 USD (six cent dix mille trois Dollars américains) par l’émission de 20.001 (vingt mille un) nouvelles parts sociales
d’une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain) (les "Nouvelles Parts Sociales"), la totalité devant être payée par
un apport en nature consistant en:
- 20.000 (vingt mille) parts sociales de Aircraft Solutions Lux XX S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée
et existant selon les lois du Luxembourg, ayant son siège social au 5c, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
186.862; et
- 1 (une) part sociale de AS 777-2012 (Offshore) Limited Bermuda, une société exonéréé ayant son siège social aux
Bermudes (l’ “Apport”).
<i>Intervention - Souscription - Paiementi>
Ici intervient ensuite l’Apporteur, représenté comme indiqué ci-dessus. L'Apporteur déclare souscrire à la Nouvelle
Part Sociale et de la payer entièrement par voie de l’Apport.
<i>Troisième résolution:i>
Il est décidé d'accepter la souscription et le paiement par l’Apporteur des Nouvelles Parts Sociales par l’Apport.
<i>Evaluationi>
L'évaluation de 20.001 USD (vingt mille un Dollars américains) a été approuvée par les gérants de la Société confor-
mément à une déclaration sur la valeur de l’Apport avec effet au 9 juillet 2014, laquelle restera annexée à cet acte pour
être soumise avec celui-ci aux formalités d’enregistrement.
<i>Preuve de l’Existence des Apportsi>
Une preuve de l’existence de l’Apport a été donnée à la Société.
<i>Intervention des gérantsi>
Interviennent ensuite:
a) M. Pedro Fernandes das Neves, en qualité de gérant, résident à 5c, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg;
b) Mme Julie K. Braun, en qualité de gérant, résident à 4600 Wells Fargo Center, 90 So 7
th
Street, Minneapolis, Etats-
Unis d'Amérique, MN 55402; et
c) Mme Virginia Strelen, en qualité de gérant indépendant, résident à 15 rue Edward Steichen, 4
ème
Etage, L-2540
Luxembourg, Grand-Duché of Luxembourg,
tous ici représentés par Mme. Claudia Rouckert, prénommée, en vertu d’une procuration contenue dans la déclaration
de valeur de l’apport;
Reconnaissant avoir été préalablement informés de l’étendue de leur responsabilité, légalement responsables en tant
que gérants de la Société en raison de l’Apport, déclarent expressément être d'accord avec la description de l’Apport,
son évaluation et confirment la validité de la souscription et du paiement.
<i>Quatrième résolution:i>
En conséquence des déclarations et résolutions ci-dessus, l’actionnariat de la Société est désormais composé comme
suit:
Clsec Holdings 1 Limited: 610.003 (six cent dix mille trois) parts sociales avec une valeur nominale de 1 USD (un Dollar
américain) chacune.
Le notaire acte que toutes les 610.003 (six cent dix mille trois) parts sociales susmentionnées, représentant l’intégralité
du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l’assemblée peut valablement décider sur la résolution prise
ci-dessous.
121054
L
U X E M B O U R G
<i>Cinquième résolution:i>
Suite aux déclarations et résolutions et l’Apport ayant été entièrement libéré, il est décidé de modifier le premier
paragraphe de l’article 8 des statuts de la Société, et de lui donner la teneur suivante:
“ Art. 8. Le capital social de la Société est fixé à 610,003 USD (six cent dix mille trois Dollars américains) représenté
par 610,003 (six cent dix mille trois) parts sociales ayant une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain) chacune."
Aucune autre modification n’est apportée à cet article.
Plus rien n'étant à l’ordre du jour, la séance est clôturée.
Dont Acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, à la date figurant au commencement de ce document.
Le document ayant été lu au mandataire de la partie comparante, ce dernier a signé avec nous, le notaire, le présent
acte original.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par le présent acte qu'à la requête de la personne
comparante mentionnée ci-dessus, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la requête de la
même partie comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.
Signé: Rouckert, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 14 juillet 2014. Relation: EAC/2014/9723. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveur ff.i>
(signé): M. Halsdorf.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2014104764/211.
(140125398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2014.
Round Point S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 81.449.
DISSOLUTION
L'an deux mille quatorze, le vingt-quatre Juin.
Pardevant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.
A COMPARU:
La société anonyme, LINK POINT S.A., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1118 Luxembourg,
23, rue Aldringen, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 137.193,
Ici représentée par Madame Joëlle MAMANE, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-1118
Luxembourg, 23, rue Aldringen,
en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 14 février 2014.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par la mandataire de la partie comparante et le notaire
instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle comparante, représentée comme dit-est a requis le notaire instrumentant d'acter:
- Que la société anonyme ROUND POINT S.A., ayant son siège social à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen,
immatriculée au RCS Luxembourg sous le numéro B 81.449 (la «Société»), a été constituée par acte du notaire instru-
mentant en date du 13 mars 2001, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations, numéro 955 du 3 novembre
2001; Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 27 juin 2003, publié
au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 884 du 28 août 2003;
- que le capital social de la société anonyme ROUND POINT S.A. s'élève actuellement à TRENTE ET UN MILLE
EUROS (31.000.- EUR) représenté par MILLE (1.000) actions d’une valeur nominale de TRENTE ET UN EUROS (31.-
EUR) chacune, entièrement libérées;
- que LINK POINT S.A., précitée, est seule propriétaire de toutes les actions et déclare avoir parfaite connaissance
des statuts et de la situation financière de la Société;
- que la partie comparante, représentée comme mentionné ci-avant, en sa qualité d’actionnaire unique de la Société,
a décidé de procéder à la dissolution anticipée et immédiate de la Société et de la mettre en liquidation;
- que l’actionnaire unique, en sa qualité de liquidateur de la Société et au vu du bilan de la Société au 10 juin 2014,
déclare que tout le passif de la Société, y compris le passif lié à la liquidation de la Société, est réglé ou dûment provisionné;
La partie comparante déclare encore que:
- l’activité de la Société a cessé;
121055
L
U X E M B O U R G
- l’actionnaire unique est investi de l’entièreté de l’actif de la Société et déclare prendre à sa charge l’entièreté du passif
de la Société qu’il soit connu et impayé, ou inconnu et non encore payé, le bilan au 10 juin 2014 étant seulement un des
éléments d’information à cette fin;
- suite aux résolutions ci-avant, la liquidation de la Société est à considérer comme accomplie et clôturée;
- décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société;
- il y a lieu de procéder à l’annulation de toutes les actions et/ou du registre des actionnaires;
- les livres et documents de la Société devront être conservés pendant la durée légale de cinq ans à L-1118 Luxembourg,
23, rue Aldringen.
Toutefois, aucune confusion de patrimoine entre la société dissoute et l’avoir social de, ou remboursement à, l’ac-
tionnaire unique ne pourra se faire avant le délai de trente jours (article 69 (2) de la loi sur les sociétés commerciales) à
compter de la publication du présent acte et sous réserve qu’aucun créancier de la Société présentement dissoute et
liquidée n’aura exigé la constitution de sûretés.
<i>Frais.i>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge
en raison de présentes, sont évalués approximativement à neuf cents euros (900.-EUR).
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire instrumentant
par ses nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. MAMANE, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 26 juin 2014. Relation: LAC/2014/29500. Reçu soixante-quinze euros (EUR
75,-).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juillet 2014.
Référence de publication: 2014106076/59.
(140126839) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2014.
MD Engineering S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1318 Luxembourg, 9, rue des Celtes.
R.C.S. Luxembourg B 146.737.
Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2014101372/10.
(140121118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.
BM Fund Company, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-1616 Luxembourg, 28-32, place de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 159.952.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale annuelle tenue le 30 juin 2014i>
L'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires renouvelle, pour une période de un an prenant fin à la prochaine
Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en Juin 2015, les mandats d'Administrateur de Messieurs Ahmed AL ABRI,
Karumathil GOPAKUMAR et Ali Said ALI.
L'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires renouvelle, pour une période de un an prenant fin à la prochaine
Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en Juin 2015, en qualité de Réviseur d'Entreprises Agrée, Pricewatherhou-
seCoopers, résidant professionnellement au 400, Route d'Esch, L-1014, Luxembourg, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014102924/15.
(140122064) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2014.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
121056
2M Toitures Sàrl
Act of Prod S.A.
Altor II S. à r.l.
Altrotech S.A.
Attika S.A.
BCL Fixed Income S.à r.l.
BM Fund Company
Bregal-Birchill Investments S.à r.l.
Bregal Sagemount Investments (Luxembourg) S.à r.l.
Chamelon Topco S.à r.l.
CLSec 1 Lux S.à r.l.
Club Odemba
Codic Development
Compass International Holdings S.à r.l.
Compass Printing S.à r.l.
Digital Services XXVIII (GP) S.à r.l.
Dream Global Advisors Luxembourg S.à r.l.
Eco-Finproject S.A.
Edmund Frette S.à r.l.
Eterlux S.A.
Eufina S.A.
FL Finance S.A.
Gaïa International Financial Investment S.A.
Hamburg International S.A.
Hampton Luxembourg S.à r.l.
H.I.G. Luxembourg Holdings Twenty-Two S.à r.l.
Industrial Re S.A.
Inmet Panama II S.A.
JER Adriana S. à r.l.
Logistis Luxembourg Feeder S.A.
Malasi S.A.
Management Marketing IT & Trading S.A.
Matrix EPH 2 S.à r.l.
Matrix German Portfolio One Kaiserslautern S.à r.l.
Mawa S.A., SPF
MD Engineering S.à r.l.
Meigerhorn Etoy Holding S.à r.l.
Meigerhorn II Morges S. à r.l.
Meigerhorn Nation S.à r.l.
Meigerhorn Rosemont Holding S.à r.l.
Metinvest Development S.à r.l.
Milleland Holding S.A.
Minacom S.A.
Mitoma S.A.
Mokas
Mondi International
Mondi Services
Monroe CA BC Investment II Sàrl
Monroe CA BC Investment SARL
Monterey Investments S.A.
Morgan Stanley Luxembourg Financing II S à r.l.
Morgan Stanley Luxembourg Financing I S à r.l.
MSREF VI Spirit S.à r.l.
Neried Finance S.A.
NGS Investments S.A.
Nkozi Consulting S. à r.l.
Round Point S.A.
SCI Immo de Frisange
Swedish District Heating 1 S.à r.l.
Tomkins Holdings Luxembourg S.à r.l.