logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2508

17 septembre 2014

SOMMAIRE

Abano Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120343

Aberdeen Global Property Multi Manager

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120348

Aerium Erlangen S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

120341

Aerium Erlangen S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

120342

A-F-F Consulting S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

120338

Affret'Partners Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120343

Aida Wedo 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120342

Aircraft Holding Solutions Lux S.à r.l. . . . .

120338

Alaskan Luxembourg S.C.A.  . . . . . . . . . . . .

120339

Aldorf & Norbereit Invest S.A.  . . . . . . . . . .

120345

Alifa S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120339

Alison Holdco S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120339

Allfin Holding Luxembourg Sàrl  . . . . . . . . .

120340

AltaLux Italy S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120340

AltaLux Spain S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120344

Altho S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120340

Altimum S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120345

Altro Teatro S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120341

AMMF Investment  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120344

Ampala S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120344

Ampala S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120349

AMS Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

120349

Antala S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120351

Antias Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120383

APERAM Stainless Services & Solutions

Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120345

Apollo 10 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120338

Apollo 11 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120340

Apollo Warehouse S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

120338

Apolux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120346

Applex S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120350

ARAMIS Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . .

120350

AR Intellectual Property S.à r.l.  . . . . . . . . .

120346

Arithmex  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120357

ATEEL - Allied Technology Experts Enter-

prise of Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . .

120338

Axys Consultants Luxembourg S.A.  . . . . .

120351

Azure Global Microfinance Fund  . . . . . . . .

120339

BIOCARDEL Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

120346

Bluehouse Capital Advisors S.à r.l. . . . . . . .

120346

Caletaster S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120344

Centralis S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120351

Corporate XII  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120345

Dzeta Group S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120383

Emerging Markets Taxi Holding S.à r.l.  . .

120361

Impelect S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120348

Iona Bruxelles S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120339

M3 Lux Catering S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

120348

MCP Private Capital Fund I  . . . . . . . . . . . . .

120343

Mirae Asset Global Discovery Fund  . . . . . .

120350

Mitco Real Estate C S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

120347

MN S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120350

Montrium S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120342

Munsterfred Property S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

120343

Olays S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120342

Peakside Blueprint S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

120349

Petroleum Services Exploitation S.A.  . . . .

120341

Pétrusse Participations S.A.  . . . . . . . . . . . . .

120341

PLJ Chelsea  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120349

Prax Capital China Growth Fund III,

S.C.A., SICAR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120340

Reinbro Investments SA  . . . . . . . . . . . . . . . .

120384

Wasaby S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120347

Weatherford European Holdings (Luxem-

bourg) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120347

Yopla International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

120352

120337

L

U X E M B O U R G

Apollo Warehouse S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 168.838.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Apollo Warehouse S.à r.l.

Référence de publication: 2014100701/10.
(140120569) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

Apollo 10 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 180.134.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Apollo 10 S.à r.l.

Référence de publication: 2014100702/10.
(140120573) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

A-F-F Consulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6195 Imbringen, 13, Cité Beaulieu.

R.C.S. Luxembourg B 185.557.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 14 juillet 2014.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2014100674/11.
(140120927) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

Aircraft Holding Solutions Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5C, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 174.497.

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de rési-

dence à Esch/Alzette, en date du 19 décembre 2013 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 20 janvier 2014.

Référence de publication: 2014100685/11.
(140120248) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

ATEEL - Allied Technology Experts Enterprise of Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6871 Wecker, 14, op Huefdreisch.

R.C.S. Luxembourg B 138.685.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 07/07/2014.

G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg

Référence de publication: 2014100760/12.
(140120072) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

120338

L

U X E M B O U R G

Azure Global Microfinance Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 162.954.

Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

CREDIT SUISSE FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.

Référence de publication: 2014100714/10.
(140120470) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

Alifa S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 138.502.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014100733/10.
(140120709) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

Alaskan Luxembourg S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 178.120.

Les comptes annuels pour la période du 18 juin 2013 (date de constitution) au 31 décembre 2013 ont été déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juin 2014.

Référence de publication: 2014100686/11.
(140120147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

Alison Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 178.376.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Alison HoldCo S.à r.l.
Un Mandataire

Référence de publication: 2014100688/11.
(140120017) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

Iona Bruxelles S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 167.098.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 juillet 2014.

Maître Léonie GRETHEN
<i>Notaire

Référence de publication: 2014103244/12.
(140121637) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2014.

120339

L

U X E M B O U R G

Apollo 11 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 169.556.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Apollo 11 S.à r.l.

Référence de publication: 2014100703/10.
(140120571) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

Altho S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9570 Wiltz, 3, rue des Tondeurs.

R.C.S. Luxembourg B 175.447.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014100734/10.
(140121251) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

Allfin Holding Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12-14, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 138.090.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014100689/11.
(140121540) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

AltaLux Italy S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 118.118.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour AltaLux Italy S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2014100692/11.
(140121358) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

Prax Capital China Growth Fund III, S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme

d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6A, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 146.911.

Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg après approbation

à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires en date du 20 Juin 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 Juillet 2014.

Référence de publication: 2014103434/12.
(140122257) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2014.

120340

L

U X E M B O U R G

Aerium Erlangen S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 118.832.

Le bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014100724/9.
(140120874) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

Altro Teatro S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place de Théâtre.

R.C.S. Luxembourg B 180.941.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2014100736/10.
(140121539) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

Petroleum Services Exploitation S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 6, Zoning Vulcalux.

R.C.S. Luxembourg B 63.219.

Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fiduciaire ARBO SA
Signature

Référence de publication: 2014103445/11.
(140121994) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2014.

Pétrusse Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 54.256.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 20 juin 2014

1. Les mandats d'Administrateurs de:
- Mme Stéphanie Colleaux, employée privée, née le 2 décembre 1977 à Dinant, Belgique, résidant professionnellement

au 412F, Route d'Esch, L-2086 Luxembourg,

- Mme Nicole Thirion, employée privée, née le 5 décembre 1957 à Jamoigne, Belgique, résidant professionnellement

au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg,

- Mr Michel Lenoir, employé privé, né le 2 juillet 1961 à Saint-Mard, Belgique, résidant professionnellement au 412F,

route d'Esch, L-2086 Luxembourg

sont reconduits pour une nouvelle période de six (6) années jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2020.
2. Le mandat du Commissaire, FIN-CONTROLE S.A., société anonyme avec siège social au 12, rue Guillaume Kroll,

Bâtiment F, L-1882 LUXEMBOURG, est reconduit pour une nouvelle période de six (6) années jusqu'à de l'Assemblée
Générale Statutaire de l'an 2020.

Fait à Luxembourg, le 20 juin 2014.

Certifié sincère et conforme
PETRUSSE PARTICIPATIONS S.A.
Signatures
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2014103446/24.
(140121456) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2014.

120341

L

U X E M B O U R G

Aerium Erlangen S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 118.832.

Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014100725/9.
(140120875) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

Montrium S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue St. Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 167.434.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014102412/10.
(140122724) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2014.

Aida Wedo 3, Société Anonyme.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 8, place Winston Churchill.

R.C.S. Luxembourg B 178.238.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2013 de la Société Aida Wedo 3 ont été déposés au registre de commerce et

des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 juillet 2014.

Référence de publication: 2014100730/11.
(140120076) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

Olays S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 171.089.

<i>Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale tenue le 16 juin 2014 à 11h00

<i>Décisions:

1. Renouveler les mandats des administrateurs:
- Emmanuel Lebeau, ayant son adresse au 4A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg,
- Olivier Granboulan, ayant son adresse au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg,
- Jean-Michel Marq, ayant son adresse au 5, rue du Parc, L-8031 Strassen,
- André Genton, ayant son adresse au 19, Place Maréchal Lyautey, 69006 Lyon, France
Les mandats des Administrateurs arriveront à échéance à l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes annuels

de l'exercice clos au 31 décembre 2014.

2.  Renouveler  le  mandat  du  Commissaire  aux  Comptes  FIDUCIAIRE  HRT,  ayant  son  siège  social  1A,  Romescht,

Résidence Les Cerisiers n°2, L-7364 Bofferdange, dûment enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Lu-
xembourg sous le numéro B125213,

Le mandat du Commissaire aux Comptes arrivera à échéance à l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes

annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2014.

Suite à cet exposé, aucune remarque n'est formulée, l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Signatures
<i>Le Président / Le Secrétaire

Référence de publication: 2014102450/24.
(140122783) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2014.

120342

L

U X E M B O U R G

Affret'Partners Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8308 Capellen, 83, Pafebruch.

R.C.S. Luxembourg B 163.542.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014100726/9.
(140121067) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

Abano Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 57.900.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour ABANO SARL
Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2014100715/11.
(140120794) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

MCP Private Capital Fund I, Société en Commandite simple sous la forme d'une SICAF - Fonds d'Inves-

tissement Spécialisé.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 167.728.

Les comptes consolidés de la Société au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juillet 2013.

Malcolm Wilson
<i>Mandataire

Référence de publication: 2014102393/14.
(140122981) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2014.

Munsterfred Property S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 123.196.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions écrites prises par l'associé unique de la Société en date du 2 juillet 2014 que:
- Les démissions de M. Benoît BAUDUIN et de M. Patrick MOINET, gérants de classe B de la Société ont été acceptées

avec effet immédiat;

- Les personnes suivantes ont été nommées gérants de classe B de la Société, avec effet immédiat et ce pour une durée

indéterminée:

* (i) M. Marc CHONG KAN, né le 24 août 1964 à Paris, France, résidant professionnellement au 16, avenue Pasteur

L-2310 Luxembourg;

* (ii) M. Benjamin CHOURAKI, né le 31 mars 1983 à Senlis, France, résidant professionnellement au 16, avenue Pasteur

L-2310 Luxembourg;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juillet 2014.

Référence de publication: 2014102385/20.
(140122984) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2014.

120343

L

U X E M B O U R G

AMMF Investment, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 112.588.

Les comptes annuels de l'exercice clôturé au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014100737/10.
(140120043) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

Ampala S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 143.241.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014100739/10.
(140120336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

AltaLux Spain S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 118.105.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour AltaLux Spain S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2014100693/11.
(140121356) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

Caletaster S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1933 Luxembourg, 20, rue Siggy vu Lëtzebuerg.

R.C.S. Luxembourg B 174.245.

<i>Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale tenue le 16 juin 2014 à 18h00

<i>Décisions:

1. Renouveler les mandats des administrateurs:
- Jean-Claude MICHAUX, ayant son adresse 20, rue Siggy vu Lëtzebuerg, L-1933 Luxembourg.
- Anne-Marie MICHAUX, ayant son adresse 20, rue Siggy vu Lëtzebuerg, L-1933 Luxembourg.
- Emmanuel LEBEAU, ayant son adresse 4a rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg.
- Olivier GRANBOULAN, ayant son adresse 18 rue de l'eau, L-1449 Luxembourg.
Les mandats des Administrateurs arriveront à échéance à l'Assemblée Générale qui statuera sur les Comptes Annuels

de l'exercice clos au 31 décembre 2014.

2.  Renouveler  le  mandat  du  Commissaire  aux  Comptes  FIDUCIAIRE  HRT,  ayant  son  siège  social  1A,  Romescht,

Résidence les Cerisiers n°2, L-7364 Bofferdange, dûment enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Lu-
xembourg sous le numéro B125213.

Le mandat du Commissaire aux Comptes arrivera à échéance à l'Assemblée Générale qui statuera sur les Comptes

Annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2014.

Signatures
<i>Le Président / Le Secrétaire

Référence de publication: 2014101987/23.
(140122781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2014.

120344

L

U X E M B O U R G

APERAM Stainless Services &amp; Solutions Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4802 Rodange, Site du PED.

R.C.S. Luxembourg B 48.965.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014100747/9.
(140120868) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

Aldorf &amp; Norbereit Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5619 Mondorf-les-Bains, 5, rue John Gruen.

R.C.S. Luxembourg B 152.129.

Der Jahresabschluss vom 31.12.2012 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014100732/9.
(140121096) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

Altimum S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 173.535.

Le Bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014100735/9.
(140120734) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

Corporate XII, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 147.895.

1. ES WIRD FESTGESTELLT UND BESTÄTIGT, dass Herr Nikolaus Schmidt-Narischkin sein Mandat als Mitglied und

Vorsitzender des Verwaltungsrates mit Wirkung zum 30. Juni 2014 niedergelegt hat.

2. ES WIRD BESCHLOSSEN, dass mit Wirkung vom 1. Juli 2014 Herr Dr. Torben Lütje für Herrn Nikolaus Schmidt-

Narischkin in den Verwaltungsrat aufgenommen wird.

3. Zugleich wird beschlossen, dass Herr Dr. Torben Lütje den Vorsitz des Verwaltungsrates der Gesellschaft über-

nimmt.

4. Die Bestellung von Herrn Dr. Torben Lütje muss von der nächstfolgenden Gesellschafterversammlung bestätigt

werden.

5. Das Mandat beginnt am 01. Juli 2014 und endet mit der Generalversammlung, die im Jahr 2015 stattfindet und über

das Geschäftsjahr 2014 beschließt.

6. ES WIRD FESTGESTELLT, dass sich der Verwaltungsrat der Gesellschaft demnach ab dem 1. Juli 2014 wie folgt

zusammensetzt:

Dr. Torben Lütje (Vorsitzender)
Manfred Bauer
Leif Bjurström
Heinz-Wilhem Fesser
Dr. Norman Gehrke
Holger Naumann
Klaus-Michael Vogel

Luxemburg.

Référence de publication: 2014101966/27.
(140123513) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2014.

120345

L

U X E M B O U R G

Apolux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 125.842.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014100749/9.
(140121385) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

AR Intellectual Property S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 176.750.

Le bilan au 31 mars 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juillet 2014.

Référence de publication: 2014100752/10.
(140120059) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

Bluehouse Capital Advisors S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 125.000,00.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 137.666.

<i>Extrait des résolutions des associés du 10 juillet 2014

Les associés de Bluehouse Capital Advisors S.à r.l. (la "Société"), ont décidé d'accepter de renommer Pricewaterhou-

seCoopers S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 400, route d'Esch, B.P. 1443, L-1014
Luxembourg et immatriculée sous le numéro B 65477 auprès du Registre du Commerce et des Sociétés, en qualité de
Réviseur d'entreprise agrée jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'année 2015.

Luxembourg, le 11 juillet 2014.

Référence de publication: 2014100798/14.
(140120452) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

BIOCARDEL Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 4A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 131.849.

<i>Extrait du Procès-Verbal de la Prise de Décision de l'assemblée générale par voie circulaire en date du 09 juillet 2014

L'Assemblée Générale, après s'être considérée valablement convoquée et après avoir valablement délibéré, a décidé

de:

- Prendre acte des démissions de Mme Sandrine Renaudin Watrin, de M. Emmanuel Roque, et de M. René Delarue de

leurs fonctions d'administrateurs.

- Nommer aux fonctions d'administrateur M. Louis Pharand, né le 7 janvier 1954 à Lachute, et résidant 746 av. des

grenats, Québec, QC G2L 2Y6, Canada. Son mandat prendra fin à l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'année 2017.

- Nommer aux fonctions d'administrateur M. Yehuda Kops, né le 16 juillet 1954 à New York et résidant profession-

nellement 634 av. de la Louvière, Laval, QC H7M, Canada. Son mandat prendra fin à l'Assemblée Générale qui se tiendra
en l'année 2017.

- Nommer aux fonctions d'administrateur Mme Francesca Albano, née le 8 juin 1961 à Montréal et résidant profes-

sionnellement 634 av. de la Louvière, Laval, QC H7M, Canada. Son mandat prendra fin à l'Assemblée Générale qui se
tiendra en l'année 2017.

Signature.

Référence de publication: 2014105469/21.
(140125794) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2014.

120346

L

U X E M B O U R G

Wasaby S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 130.255.

Par décision du Conseil d'administration du 14 juillet 2014:
LANNAGE S.A., société anonyme, R.C.S. Luxembourg B-63130, 42 rue de la Vallée, L -2661 Luxembourg, a désigné

comme représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour son compte au conseil d'admi-
nistration de la société WASABY S.A., Monsieur Stanislas BUNETEL, 42 rue de la Vallée, L - 2661 Luxembourg, en
remplacement de Monsieur Guy Baumann, démissionnaire.

Luxembourg, le 17 juillet 2014.

<i>Pour: WASABY S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme

Référence de publication: 2014105426/17.
(140125257) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2014.

Weatherford European Holdings (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 25.100,00.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 150.992.

<i>Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 13 juin 2014

1. M. Michael Niederer, administrateur de sociétés, a démissionné de son mandat de gérant A en date du 16 mai 2014.
2. M. Bastiaan van Houts, administrateur de sociétés, né à Alphen aan den Rijn (Pays-Bas), le 27 mai 1974, demeurant

professionnellement au 1 Bahnhofstrasse, CH-6340 Zug (Suisse), a été nommé avec effet au 16 mai 2014 comme gérant
A pour une durée indéterminée.

Veuillez prendre note que l'adresse professionnelle de Madame Mounira Meziadi et Monsieur Andrew O'Shea, gérants

B, se situe désormais au L-2453 Luxembourg, 6 rue Eugène Ruppert.

Luxembourg, le 17 juillet 2014.

Pour extrait et avis sincères et conformes
<i>Pour Weatherford European Holdings (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2014105427/18.
(140125393) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2014.

Mitco Real Estate C S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1319 Luxembourg, 91, rue Cents.

R.C.S. Luxembourg B 124.034.

<i>Extrait des résolutions adoptées par l'associé unique de la société le 7 juillet 2014

Il résulte des résolutions de l'associé unique du 7 juillet 2014 que:
1. L'associé unique a décidé de transférer le siège social de la société à responsabilité limité MITCO REAL ESTATE C

S.àr.l. (B124.034) au L-1319 Luxembourg, 91 rue Cents.

2. Acceptation de la démission du gérant et gérant-délégué Monsieur Christian BÜHLMANN, demeurant profession-

nellement à L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach, et du gérant Monsieur Alexandre TASKIRAN, demeurant
professionnellement à L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.

3. La société sera engagée par la signature individuelle du gérant unique Monsieur Olivier GOÏOT.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juillet 2014.

Pour extrait conforme
<i>Pour la gérance

Référence de publication: 2014103362/19.
(140122035) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2014.

120347

L

U X E M B O U R G

Impelect S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 11, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 112.637.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Par jugement du 10 juillet 2014, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public
en leurs conclusions, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de la liquidation de la société à responsabilité
limitée IMPELECT SARL, avec siège social à L-1273 Luxembourg, 11, rue de Bitbourg, de fait inconnue à cette adresse.

Pour extrait conforme
Maître Karima HAMMOUCHE
<i>Le liquidateur
2 avenue du X septembre
L-2550 Luxembourg

Référence de publication: 2014104590/17.
(140125116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2014.

Aberdeen Global Property Multi Manager S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 119.541.

<i>Extrait des résolutions de l'actionnaire unique tenue au siège social le 30 juin 2014

L'actionnaire unique (l' «Actionnaire») a décidé:
- de renouveler le mandat des administrateurs suivants pour une période d'un an qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée

Générale Ordinaire qui se tiendra en 2015:

* Charles Macrae;
* Elisabeth Weiland;
* Pertti Vanhanen;
* Claire George;
- de ne pas renouveler le mandat de Deloitte Audit en tant que de Réviseur d'Entreprises Agréé de la Société et d'élire

KPMG Luxembourg Sàrl, résidant au 9 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, comme réviseur d'entreprises agréé de la
Société pour une période d'un an qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2015.

Référence de publication: 2014104596/18.
(140125057) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2014.

M3 Lux Catering S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1899 Kockelscheuer, 42, route de Bettembourg.

R.C.S. Luxembourg B 79.853.

Concernant l'associé
Nom: VENTINI
Prénoms: Mario
Changement d'adresse: 29, route de Cessange - L-3347 Leudelange
Date et Lieu de naissance: 18/04/1967 à Metz (France)
Concernant le gérant
Nom: VENTINI
Prénoms: Mario
Changement d'adresse: 29, route de Cessange - L-3347 Leudelange
Date et Lieu de naissance: 18/04/1967 à Metz (France)
Date de nomination: 13/12/2000

Luxembourg, le 15/07/2014.

VENTINI Mario.

Référence de publication: 2014103379/19.
(140122342) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2014.

120348

L

U X E M B O U R G

Ampala S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 143.241.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014100740/10.
(140120337) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

AMS Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4645 Niederkorn, 145, route de Pétange.

R.C.S. Luxembourg B 83.366.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014100741/10.
(140120983) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

Peakside Blueprint S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 170.414.

Veuillez noter qu'à partir du 13 Juin 2014 l'adresse de la Société est la suivante:
Peakside Blueprint S.à r.l.
46A, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Declan McGrath.

Référence de publication: 2014101470/14.
(140120206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

PLJ Chelsea, Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 12.000,00.

Siège social: L-8308 Capellen, 89E, Parc d'activités.

R.C.S. Luxembourg B 187.415.

<i>Extrait de cession de parts

Il résulte de contrats de cession de parts sociales signés en date du 3 juin 2014 que la société LJ CAPITAL LIMITED,

constituée le 11 juin 2009 au Royaume-Uni, dont le siège est situé au 9, Clifford Street, Londres W1S2FT (Royaume-
Uni), et immatriculée auprès du Registre des Sociétés d'Angleterre et du Pays de Galles sous le numéro 6931299 a cédé:

- 300 (trois cent) parts sociales qu'elle détenait dans la société PLJ CHELSEA S. à r. l. à la société PETERSON (CHELSEA

ISLAND) COMPANY LIMITED, constituée le 22 janvier 2014 à Hong Kong, dont le siège est situé au 1-3, Wyndham
Street, Hong Kong, immatriculée auprès du Registre des Sociétés de Hong Kong sous le numéro 2030162,

-  400  (quatre  cent)  parts  sociales  qu'elle  détenait  dans  la  société  PLJ  CHELSEA  S.  à  r.  l.  à  la  société  DANEHILL

CORPORATE LIMITED, constituée le 12 août 2008 aux Iles Vierges Britanniques, dont le siège est situé au P.O. Box
3175,  Road  Town,  Tortola,  Iles  Vierges  Britanniques,  immatriculée  auprès  du  Registre  des  Sociétés  des  Iles  Vierges
Britanniques sous le numéro 1498808.

Pour extrait
<i>La société

Référence de publication: 2014101524/20.
(140120182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

120349

L

U X E M B O U R G

Applex S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1249 Luxembourg, 4-6, rue du Fort Bourbon.

R.C.S. Luxembourg B 110.162.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014100750/9.
(140120467) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

ARAMIS Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 115.774.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014100753/9.
(140121391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

Mirae Asset Global Discovery Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-8070 Bertrange, 31, Zone d'Activités Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 138.578.

Le bilan au 31 mars 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Bertrange, le 14 juillet 2014.

<i>Pour le compte de Mirae Asset Global Discovery Fund
Citibank International plc (Luxembourg Branch)

Référence de publication: 2014102379/12.
(140122887) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2014.

MN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9806 Hosingen, 71, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 160.037.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est tenue le 11 juillet 2014 que:
1) L'assemblée générale révoque de sa qualité d'administrateur unique de la société:
- Madame Natalya Alekseevna RODRIGUES, serveuse, née à Vostok Poronaysk Sakhalin (Russie) le 4 février 1971,

demeurant à L- 7556 Mersch, 18, Place St. Michel.

2) L'assemblée générale nomme comme nouvel administrateur unique de la société:
- Monsieur Germain TEIXEIRA, serveur, né à Ettelbruck le 20 avril 1992, demeurant à L- 9905 Troisvierges, 95, Grand-

Rue, qui accepte.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblé générale des actionnaires qui se tiendra en 2020.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Hosingen, le 11 juillet 2014.

<i>Pour la société
C.F.N. GESTION S.A.
20, Esplanade - L-9227 Diekirch
B.P. 80 - L-9201 Diekirch
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014102408/24.
(140123118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2014.

120350

L

U X E M B O U R G

Axys Consultants Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R.C.S. Luxembourg B 178.585.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014100773/9.
(140120543) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

Antala S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4170 Esch-sur-Alzette, 26-28, boulevard John F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 102.666.

Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Mandataire

Référence de publication: 2014100743/10.
(140121119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

Centralis S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 113.474.

<i>Extrait des résolutions de l'assemblée générale ordinaire de la société tenue à Luxembourg le 15 juillet 2014

Les mandats d'administrateurs de la Société ont été renouvelés jusqu'à la tenue de l'assemblée générale annuelle en

relation avec l'approbation des comptes de l'exercice social prenant fin le 31 décembre 2014:

- Madame Samia RABIA, administrateur, demeurant professionnellement au 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Lu-

xembourg,

- Monsieur Sebastien FRANCOIS, administrateur, demeurant professionnellement au 8-10, Avenue de la Gare, L-1610

Luxembourg,

- Monsieur François BROUXEL, administrateur et Président permanent du Conseil d'administration, demeurant pro-

fessionnellement au 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg,

- Monsieur Tamas HORVATH, administrateur, demeurant professionnellement au 8-10, Avenue de la Gare, L-1610

Luxembourg,

- Monsieur Michel BULACH, administrateur, demeurant professionnellement au 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320

Luxembourg,

- Monsieur Daniel ADAM, administrateur, demeurant professionnellement au 8-10, Avenue de la Gare, L-1610 Lu-

xembourg,

- Monsieur Pierre METZLER, administrateur, demeurant professionnellement au 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320

Luxembourg.

Les mandats d'administrateurs-délégués de la Société ont été renouvelés jusqu'à la tenue de l'assemblée générale

annuelle en relation avec l'approbation des comptes de l'exercice social prenant fin le 31 décembre 2014:

- Monsieur Tamas HORVATH, administrateur-délégué, demeurant professionnellement au 8-10, Avenue de la Gare,

L-1610 Luxembourg,

- Monsieur Sebastien FRANCOIS, administrateur-délégué, demeurant professionnellement au 8-10, Avenue de la Gare,

L-1610 Luxembourg.

Grant Thorton Lux Audit, société anonyme établie et ayant son siège social à L-8308 Capellen, 83, Pafebruch, inscrite

au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 43298, a été reconduite dans ses fonctions
de réviseur d'entreprises agréé de la Société pour une durée expirant à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires
de la Société appelée à statuer sur les comptes de l'exercice social clos au 31 décembre 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014103871/35.
(140124606) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2014.

120351

L

U X E M B O U R G

Yopla International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2511 Luxembourg, 2, boulevard Jules Salentiny.

R.C.S. Luxembourg B 188.613.

STATUTS

L'an deux mille quatorze, le quatre juillet.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.

A comparu:

Madame GUILLOUX Stephanie, gérante de société, née le 06 juin 1970 à la Celle Saint Cloud, France, demeurant à 2,

boulevard Jules Salentiny, L-2511 Luxembourg.

La partie comparante a requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme

qu'elle déclare constituer comme suit:

Art. 1 

er

 . Forme et Dénomination.  Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des

actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de YOPLA INTERNATIONAL (la «Société») qui sera
régie par la loi du 10 aout 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi») et les présents statuts (les
«Statuts»)

La Société peut avoir un actionnaire unique (l’«Actionnaire Unique») ou plusieurs actionnaires. La Société ne sera pas

dissoute par la mort, la suspension des droits civiques, la faillite, la liquidation ou la banqueroute de l’Actionnaire Unique.

Art. 2. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il pourra être transféré en tout autre endroit de la

même commune par simple décision du Conseil d’Administration de la Société le (le «Conseil») ou, dans le cas d’un
administrateur unique, par (l’«Administrateur Unique») par une décision de l’Administrateur Unique. Toutes les réfé-
rences dans les présents statuts au Conseil son censées être des références à l’Administrateur Unique s’il n’existe qu’un
Administrateur Unique.

Lorsque le Conseil estime que des évènements extraordinaires d’ordre politique ou militaire de nature à compro-

mettre l’activité normale au siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l’étranger se produiront ou
seront imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu'à cession complète de ces cir-
constances anormales. Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, malgré le
transfert temporaire de son siège social, qui restera une société luxembourgeoise.

Par simple décision du Conseil d'Administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l’étranger.

Art. 3. Durée. La durée de la société est illimitée.
La Société peut être dissoute, à tout moment, par résolution de l’Assemblée Générale (telle que définie ci-après)

statuant comme en matière de modification des Statuts, tel que prescrit à l’Article 21, ci après.

Art. 4. Objet sociaux.
4.1 La société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, l’organisation, l’aménagement, dans le secteur privé ou

public, de foires, salons professionnels, congrès, illuminations de Noël, illuminations diverses dans les domaines précités.

Mais aussi la fabrication, la production, la vente, la location, la mise à disposition de tous produits qui touchent les

illuminations, les décors de Noël ou liés à des événements culturels, festifs, évènementiels, ou exceptionnelles qui pour-
ront être importés ou exportés.

4.2 La société a également pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, la commercialisation, la mise à disposition,

la location, de tous produits se rapportant à l’artisanat dans le monde, qui pourront être importés ou exportés dans le
monde entier.

4.3 La Société a également pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la Société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».

La société a également pour objet la gestion de son propre patrimoine immobilier par l’achat, la location, la mise en

valeur et la vente de toutes propriétés et droits immobiliers, aussi bien au Grand Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Dans l’exercice de toutes ses activités, la société pourra également établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien au Grand Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

La Société a le pouvoir de représenter une société en formation à son acte de constitution.

120352

L

U X E M B O U R G

La Société a également le pouvoir d’être administrateur, administrateur délégué, gérant ou commissaire dans d’autres

sociétés.

4.4 La Société a également pour objet (i) l’acquisition, la détention et la cession sous quelque forme que ce soit et par

tous moyens, directement ou indirectement, de participations, droits, intérêts et engagements dans des sociétés luxem-
bourgeoises et étrangères, (ii) l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière et l’aliénation par vente,
échange ou de tout autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs mobilières ou instruments
financiers de toutes espèces, ainsi que des contrats portant sur les titres précités ou y relatifs et (iii) la possession,
l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille (composé notamment des actifs tels que ceux définis
au points (i) et (ii) ci-dessus).

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l’émission de titres de créances, obligations

et créances et Titres représentatifs de dette. La Société peut accorder des prêts (subordonnés ou non subordonnés) ou
d’autres formes de financement à la société. Elle peut également prêter des fonds (y compris ceux résultant des emprunts
et/ou des titres représentatifs de dette) à ses filiales et sociétés affiliées.

En outre, la société pourra exercer toute autre activité commerciale à moins qu’elle ne soit spécialement réglementée.

D'une façon générale, elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se ratta-
chant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou développer la réalisation.

La société peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses

obligations ou les obligations de ses filiales, de sociétés affiliées ou de toute autre société. La Société pourra en outre
nantir, céder, grever de charges ou créer toutes sûretés sur tout ou une partie de ses avoirs.

Art. 5. Capital social. Le capital social est fixé à 31.000 Euros (trente et un mille euros) représenté par 310 (trois cent

dix) actions ordinaires au porteur d’une valeur nominale de 100 € (cent euros) chacune, subdivisés en trente et une (31)
actions de classe A, trente et une (31) actions de classe B, trente et une (31) actions de classe C, trente et une (31)
actions de classe D, trente et une (31) actions de classe E, trente et une (31) actions de classe F, trente et une (31) actions
de classe G, trente et une (31) actions de classe H, trente et une (31) actions de classe I, trente et une (31) actions de
classe J chacune des actions ayant une valeur nominales de 100 €.

Le capital autorisé est fixé à 310.000 Euros (trente cent dix mille euros) représenté par 3.100 (trois mille cent dix)

actions d’une valeur nominale de 100 € (cent euros) chacune, subdivisés en trois cent dix (310) actions de classe A, trois
cents dix (310) actions de classe B, trois cents dix (310) actions de classe C, trois cents dix (310) actions de classe D,
trois cents dix (310) actions de classe E, trois cents dix (310) actions de classe F, trois cents dix (310) actions de classe
G, trois cents dix (310) actions de classe H, trois cents dix (310) actions de classe I, trois cents dix (310) actions de classe
J chacune des actions ayant une valeur nominales de 100 €.

Le Conseil d'Administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 4 juillet 2019, à augmenter

en temps qu'il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.

Ces augmentations du capital peuvent, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration, être souscrites et

émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission à libérer totalement ou partiellement en espèces, en nature
ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société ou même,
ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, pour le cas ou
l’assemblée ayant décidé ces reports, réserves ou primes, l’a prévu, ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'adminis-
tration.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.

Art. 6. Actions. Les actions sont nominatives ou au porteur.
Un registre de(s) actionnaire(s) de la Société sera tenu au siège social de la Société ou il pourra être consulté par tout

actionnaire. Ce registre contiendra le nom de chaque actionnaire, sa résidence ou son domicile élu, le nombre d’actions
qu’il détient, les montants qu’il détient, les montants libérés pour chacune de ces actions, ainsi que la mention des transferts
d’actions et les dates de ces transferts. La propriété des actions sera établie par inscription dans ledit registre.

Art. 7. Transfert des actions. Le transfert des actions peut se faire par une déclaration écrite de transfert inscrite dans

le registre de(s) actionnaire(s) de la Société, cette déclaration de transfert devant être signée par le cédant et le cession-
naire ou par des transfert devant être signée par le cédant et le cessionnaire ou par des personnes détenant les pouvoirs
de représentation de l’article 1690 du code civil luxembourgeois relatives à la cession de créances.

La Société pourra également accepter comme preuve de transfert d’actions d’autres instruments de transfert, dans

lesquels les consentements du cédant et du cessionnaire sont établis, jugés suffisants par la Société.

120353

L

U X E M B O U R G

Art. 8. Assemblées des actionnaires de la Société. Dans le cas d’une pluralité d’actionnaires, toute assemblée des

actionnaires de la Société régulièrement constituée (l’«Assemblée Générale») représentera l’ensemble des actionnaires
de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus étendus afin d’ordonner, d’effectuer ou de ratifier les actes relatifs à toutes
les opérations de la Société.

Dans le cas d’un actionnaire unique, l’Actionnaire Unique aura tous les pouvoirs conférés à l’Assemblée Générale.

Dans  ces  Statuts,  toute  référence  aux  décisions  prises  ou  aux  pouvoirs  exercés  par  l’Assemblée  Générale  sera  une
référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l’Actionnaire Unique tant que la Société n’a qu’un Actionnaire
Unique.

Les décisions prises par l’Actionnaire Unique sont documentées par voie de procès-verbaux.
L’Assemblée Générale annuelle se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise à Luxembourg au siège social de la

Société ou à tout autre endroit de la commune du siège social indiqué dans les convocations de cette assemblée, chaque
année le 30 juin à 18h. Si ce jour est férié pour les établissements bancaires à Luxembourg, l’Assemblée Générale annuelle
se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

L’Assemblée Générale annuelle pourra se tenir à l’étranger si le Conseil constate souverainement que des circons-

tances exceptionnelles le requièrent.

D’autres  assemblées  des  actionnaires  de  la  Société  pourront  se  tenir  aux  lieu  et  heure  spécifiés  dans  les  avis  de

convocations de l’assemblée.

Tout actionnaire peut participer à une Assemblée Générale par conférence téléphonique, vidéoconférence ou tout

autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les actionnaires participant à l’assemblée peuvent être identifiés,
(ii) toutes les personnes participant, (iii) l’assemblée est retransmise en direct et (iv) les actionnaires peuvent valablement
délibérer.

La participation à une assemblée par un tel moyen de communication équivaudra à une participation en personne à

une telle assemblée.

Art. 9. Délais de la convocation, quorum, procurations et avis de convocation. Les délais de convocation et quorum

requis par la Loi seront applicables aux avis de convocation et à la conduite des Assemblées Générales, dans la mesure
où il n’en est pas disposé autrement dans les Statuts.

Chaque action donne droit à une voix.
Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la Loi ou par les présents Statuts, les décisions de l’Assemblée

Générale dûment convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés et votants.

Chaque actionnaire pourra agir à toute Assemblée Générale en désignant un mandataire par écrit, soit par lettre, par

télécopie ou e-mail reçu dans des circonstances permettant de confirmer l’identité de l’expéditeur.

Si tous les actionnaires de la Société sont présents ou représentés à un Assemblée Générales, et déclarent avoir été

dûment convoqués et informés de l’ordre du jour de l’assemblée, celle ci pourra être tenue sans convocations préalable.

Les actionnaires peuvent voter par écrit (au moyen d’un bulletin de vote) sur des résolutions soumises à l’Assemblée

Générale à condition que les bulletins de vote écrits incluent (1) les nom, prénom, adresse et signature des actionnaires
concernés, (2) l’indication des actions pour lesquelles l’actionnaire exercera son droit, (3) l’ordre du jour tel que décrit
dans l’avis de convocation et (4) les instructions de vote (approbation, refus, abstention) exprimées pour chaque point
de l’ordre du jour. Les bulletins de vote originaux devront être reçus par la Société avant la tenue de l’Assemblée Générale
en question.

Art. 10. Administration. Aussi longtemps que la Société a un Actionnaire Unique ou lorsque la Loi le permet, la Société

peut-être administrée par un administrateur unique (l’«Administrateur Unique») qui n’a pas besoin d’être un actionnaire
de la Société. Lorsque la Loi l’exige, la Société sera administrée par un Conseil composé d’au moins trois (3) administra-
teurs qui n’ont pas besoin d’être actionnaires de la Société. Le(s) administrateurs sera/seront élu(s) pour un terme de 6
ans et seront rééligibles.

Lorsqu’une personne morale est nommée administrateur de la Société (la «Personne Morale»), la Personne Morale

doit désigner un représentant permanent qui représentera la Personne Morale en tant qu’Administrateur Unique ou en
tant que membre du Conseil conformément à l’article 51 bis de la Loi.

Le(s) administrateur(s) seront élus par l’Assemblée Générale. Les actionnaires de la Société détermineront également

le nombre d’administrateurs et rémunération. Un administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être
remplacé à tout moment par décision de l’Assemblée Générale.

Un administrateur peut être révoqué avec ou sans cause et/ou remplacé à tout moment par une résolution adoptée

par l’Assemblée Générale.

En cas de vacance d’un poste d’administrateur pour cause de décès, de retraite ou toute autre cause, les administrateurs

restants pourront élire, à la majorité des votes, un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste devenu vacant
jusqu’à la prochaine Assemblée Générale. En l’absence d’administrateur disponible, l’Assemblée Générale devra rapide-
ment être réunie par le commissaire aux comptes et se tenir pour nommer de nouveaux administrateurs.

Art. 11. Réunion du Conseil. Le Conseil doit nommer un président (Le «Président») parmi ses membres et peut

designer un secrétaire, administrateur ou non, qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil

120354

L

U X E M B O U R G

et des décisions de l’Assemblée Générale ou des résolutions prises par l’Associé Unique. Le président présidera toutes
les réunions du Conseil et toute Assemblée Générale. En son absence, l’Assemblée Générale ou les autres membres du
Conseil (le cas échéant) nommeront un autre président pro tempore qui présidera la réunion en question, par un vote
à la majorité simple.

Le Conseil se réunira sur convocation du Président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans l’avis de convo-

cation qui sera au Luxembourg.

Avis écrit de toute réunion du Conseil sera donné à tous les administrateurs avant la date prévue pour la réunion, sauf

s’il y a urgence, auquel cas la nature de cette urgence sera mentionnée brièvement dans l’avis de convocation de la réunion
du Conseil.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les membres du Conseil sont présents ou

représentés lors de l’assemblée et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et avoir pleine connaissance de son
ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation écrite avec l’accord de chaque membre du Conseil donné par
écrit soit par lettre, télécopie ou mail reçu dans des circonstances permettant de confirmer l’identité de l’expéditeur.
Une convocation spéciale ne serra pas requise pour des réunions se tenant à une heure et à un endroit prévus dans un
échéancier préalablement adopté par une résolution du Conseil.

Tout membre du Conseil peut se faire représenter à toute réunion du Conseil en désignant par écrit soit par lettre,

télécopie ou mail reçu dans des circonstances permettant de confirmer l’identité de l’expéditeur, un autre administrateur
comme son mandataire.

Chaque membre du Conseil peut, à toute réunion du Conseil désigner un membre du Conseil pour le représenter et

voter en son nom et à sa place à condition qu’un membre donné du Conseil ne puisse pas représenter plus d’un de ses
collègues et qu’au moins deux membres du Conseil soient toujours physiquement présents ou assistent à la réunion du
Conseil d’Administration par le biais de tout moyen de communication du Conseil par conférence téléphonique, vidéo-
conférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les administrateurs participant à la réunion
peuvent être identifiés, (ii) toutes les personnes participant, (iii) la réunion est retransmise en direct et (iv) les adminis-
trateurs peuvent valablement délibérer. La participation à une réunion par un tel moyen de communication équivaudra à
une participation en personne à une telle réunion.

Le Conseil ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs de la Société est

présente ou représentée à une réunion du Conseil. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs
présents ou représentés à cette assemblée. Dans le cas d’une réunion, il existe une parité des votes pour et contre une
résolution, la voix du président de la réunion ne sera pas prépondérante.

Le Conseil peut également en toutes circonstances et à tout moment, avec l’assentiment unanime, passer des réso-

lutions par voie circulaire et les résolutions écrites signées par tous les membres du Conseil seront aussi valables et
effectives que si elles étaient passées lors d’une réunion régulièrement convoquée et tenue. Ces signatures peuvent
apparaître sur un seul document ou plusieurs copies de la même résolution et seront établies par lettre, télécopie, ou
mail reçu dans des circonstances permettant de confirmer l’identité de l’expéditeur.

Le présent Article 11 ne s’applique pas au cas où la Société est administrée par un administrateur Unique.

Art. 12. Procès verbaux des réunions du Conseil ou des résolutions de l’Administrateur Unique. Les procès verbaux

de toute réunion du conseil doivent être signés par le Président de la réunion en question ou le secrétaire, et les réso-
lutions prises par l’Administrateur Unique seront inscrites dans un registre tenu au siège social de la Société.

Les copies ou extraits de procès verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le Président, le

secrétaire ou deux membres du Conseil, ou l’Administrateur Unique.

Art. 13. Pouvoirs du Conseil. Le Conseil a les pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes de disposition

et d’administration dans l’intérêt de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou par les Statuts
à l’Assemblée Générale sont de la compétence du Conseil.

Art. 14. Délégation de pouvoirs.  Le  Conseil  peut  nommer  toute  personne  aux  fonctions  de  délégué  à  la  gestion

journalière, lequel pourra mais de devra pas être actionnaire ou membre du conseil, et qui aura les pleins pouvoirs pour
agir au nom de la Société pour tout ce qui concerne la gestion journalière et les affaires de la Société.

Art. 15. Signatures autorisées.  La  Société  engagée  en  toute  circonstances  (y  compris  dans  le  cadre  de  la  gestion

journalière), vis-à-vis des tiers par (i) la signature conjointe de deux membres du Conseil, ou (ii) dans le cas d’un Admi-
nistrateur Unique, la signature de l’Administrateur Unique, ou (iii) par la signatures conjointes de toutes personnes à qui
de tels pouvoirs de signature auront dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.

Art. 16. Conflit d’intérêts. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une quelconque autre société ou

entité ne seront affectés ou invalidés par le fait qu’un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société
auraient un intérêt personnel dans, ou est administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé d’une telle société ou
entité filiale ou affiliée de la Société.

Tout administrateur ou fondé de pouvoir de la Société, qui est administrateur, fondé de pouvoir ou employé d’une

filiale ou une société affiliée avec lequel la Société contracterait ou s’engagerait autrement en affaires, ne pourra en raison

120355

L

U X E M B O U R G

de sa position dans cette autre société ou entité, être empêché de délibérer, de voter ou d’agir en relation avec un tel
contrat ou autre affaire.

Au cas où un administrateur de la Société aurait un intérêt personnel et contraire dans une quelconque affaire de la

Société, cet administrateur devra informer le Conseil de son intérêt personnel et contraire et il ne délibérera et ne
prendra pas part au vote sur cette affaire, et un rapport devra être fait sur celle affaire et cet intérêt personnel de cet
administrateur à la prochaine Assemblée Générale.

Si la Société a un Administrateur Unique, les transactions conclues entre la société et l’Administrateur Unique et dans

lesquelles l’Administrateur conclues entre la Société et l’Administrateur Unique concernant les opérations réalisées dans
le cadre ordinaire des affaires courantes de la Société lesquelles sont conclues à des conditions normales.

Art. 17. Commissaire aux comptes. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires

aux comptes. Le commissaire aux comptes sera élu pour une période maximale de six (6) ans et sera rééligible.

Le commissaire aux comptes sera nommé par l’Assemblée Générale qui détermine leur nombre, leur rémunération

et la durée de leur mandat. Le commissaire aux comptes en fonction peut être révoqué à tout moment, avec ou sans
motif, par l’Assemblée Générale.

Art. 18. Exercice social. L’exercice social commencera le 1 

er

 janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre

de chaque année.

Art. 19. Affectation des bénéfices. Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société 5% (cinq pour cent) qui seront

affectés à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint 10% (dix pour
cent) du capital social de la Société tel qu’il est fixé ou tel que celui ci aura été augmenté ou réduit de tout temps,
conformément à l’article 5 des Statuts.

L’Assemblée Générale décidera de l’affectation du solde restant du bénéfice net annuel.
Les dividendes pourront être payés en euros ou en toute autre devise choisie par le Conseil et devront être payés au

lieu et place choisis par le Conseil. Le Conseil peut décider de payer des dividendes intermédiaires sous les conditions
et dans les limites fixées par la Loi.

Art. 20. Dissolution et liquidation. La Société peut être dissoute, à tout moment, par une décision de l’Assemblée

Générale statuant comme en matière de modification des présents Statuts, tel qu’écrit à l’Article 21 ci- après. En cas de
dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être
des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par la décision de l’Assemblée Générale décidant cette
liquidation. L’Assemblée Générale déterminera également les pouvoirs et la rémunération du ou des liquidateurs.

Art. 21. Modifications statutaires. Les présents Statuts pourront être modifiés de tout temps par l’Assemblée Générale

extraordinaire dans les conditions de quorum et de majorité requise par la Loi.

Art. 22. Droit applicable. Toutes les matières qui ne seront pas régies expressément par les présents Statuts seront

réglées en application de la Loi.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le à la date de la constitution et se terminera le 31 décembre 2014.
La première assemblée Générale annuelle se tiendra en 2015.

<i>Souscription

Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, la comparante Madame Stéphanie GUILLOUX, prénommée, déclare

qu’elle a souscrit trois cent dix (310) actions représentant la totalité du capital social de la Société, et plus particulièrement
à:

- 31 actions de classe A
- 31 actions de classe B
- 31 actions de classe C
- 31 actions de classe D
- 31 actions de classe E
- 31 actions de classe F
- 31 actions de classe G
- 31 actions de classe H
- 31 actions de classe I
- 31 actions de classe J
Toutes ces actions ont été libérées par l’Actionnaire à la hauteur de 100% (cent pour cent) de sorte que le montant

de trente et un mille euros (31.000,00 €) est mis à la libre disposition de la Société, une preuve de laquelle a été présentée
au notaire instrumentant.

120356

L

U X E M B O U R G

<i>Résolutions de l’actionnaire unique

L’Actionnaire Unique ci-dessus prénommé, représentant l’intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions

suivantes:

1. la personne suivante est nommée en tant qu’administrateur unique jusqu'à l’Assemblée Générale annuelle qui se

tiendra en 2019:

Madame Stéphanie GUILLOUX, gérante de sociétés, née le 06 juin 1970 à la Celle Saint Cloud, France, demeurant au

2, boulevard Jules Salentiny, L-2511 Luxembourg.

2. Que la personne suivante sera nommée commissaire au compte au compte de la société jusqu'à l’Assemblée Gé-

nérale annuelle qui se tiendra en 2019:

La société à responsabilité limitée DCA.lu, ayant son siège social au 55, Val Fleuri, L-1526- Luxembourg et enregistrée

auprès du Registre du Commerce et des Société de Luxembourg sous le numéro B168768, représentée par son gérant
Monsieur Vincent DEPRINCE, conseil fiscal et expert-comptable.

3. Que le siège social de la société est établi au 2, boulevard Jules Salentiny, L-2511 Luxembourg.

DONT ACTE, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture faite, la partie comparante a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: S. Guilloux et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 9 juillet 2014. Relation: LAC/2014/32013. Reçu soixante-quinze euros Eur

75.-

<i>Le Receveur

 (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d’inscription au Registre de

Commerce.

Luxembourg, le 15 juillet 2014.

Référence de publication: 2014103647/306.
(140122399) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2014.

Arithmex, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2233 luxembourg, 35, rue Auguste Neyen.

R.C.S. Luxembourg B 188.511.

STATUTES

In the year two thousand fourteen, on the twenty seventh day of June.
Before Me Paul DECKER, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Mrs Marie-Thérèse DISCRET, manager, residing in L-2311 Luxembourg, 153, avenue Pasteur.
Such appearing party has requested the undersigned notary to enact the following articles of incorporation (the Ar-

ticles) of a company, which he declares to establish as follows:

Art. 1. A limited liability company is hereby formed, that will be governed by these articles and by the relevant legislation.
The name of the company is “Arithmex”.

Art. 2. The registered office is established in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
It may be transferred to any other place within the Grand-Duchy of Luxembourg by collective decision of the members.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activities

of the registered office, or with easy communication between the registered office and abroad, the registered office shall
be declared to have been transferred abroad provisionally, until the complete cessation of such extraordinary events.
Such provisional transfer, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the
registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the Company which is best
situated for this purpose under such circumstances.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The Company's purpose shall be, in Luxembourg and abroad, for its own account or for third parties, all activities

of accounting, constitution, domiciliary, bookkeeping, administration and management, tax advice, any corporation or
other legal vehicle incorporated in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad, including all activities of analytical and
business consultancy with regard to the situation and operation of companies and other legal vehicles. It can make all
services directly or indirectly related to such operations, all in the broadest sense authorized by law.

The corporation may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of

real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

120357

L

U X E M B O U R G

Art. 5. The corporate capital of the company is fixed at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) divided

into 100 (one hundred) shares with a nominal value of 125- (one hundred and twenty five) each.

Art. 6. The capital may be increased or reduced at any time as laid down in article 199 of the law concerning Commercial

Companies.

Art. 7. Each share entitles its owner to a proportional right in the company's assets and profits.

Art. 8. The shares are freely transferable among members. The shares transfer inter vivos to non-members is subject

to the consent of at least seventy-five percent of the members' general meeting or of at least seventy-five percent of the
company's capital. In the case of the death of a member, the shares transfer to non-members is subject to the consent
of no less than seventy-five percent of the votes of the surviving members. In any event the remaining members have a
pre-emption right which has to be exercised within thirty days from the refusal of transfer to a non-member.

Art. 9. The Company shall not be dissolved by reason of death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of

the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 10. For no reason and in no case, the heirs, creditors or other rightful claimants of the members are allowed to

pursue the sealing of property or documents of the company.

Art. 11. The company will be managed by one or several managers who need not to be members and who are appointed

by the general meeting of members.

Towards third parties, the Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager. In case

of several managers, the managers have, by the joint signature of any two of them, the most extensive powers to act on
behalf of the company in all circumstances. If the managers are temporarily unable to act, the company's affairs can be
managed by two members acting under their joint signature.

Art. 12. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible. As agents of the company,

they are responsible for the correct performance of their duties.

Art. 13. Every member may take part in the collective decisions. He has a number of votes equal to the number of

corporate units he owns and may validly act at the meetings through a special proxy.

Art. 14. Collective decisions are only valid if they are adopted by the members representing more than half of the

capital. However, decisions concerning the amendment of the Articles of Incorporation are taken by a majority of the
members representing three quarters of the capital.

Art. 15. The business year begins on January 1 

st

 and ends on December 31 

st

 of each year.

Art. 16. Every year on December 31 

st

 , the annual accounts are drawn up by the managers.

Art. 17. The financial statements are at the disposal of the members at the registered office of the company.

Art. 18. At least 5% of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund. Such contri-

bution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches 10% of the corporate capital.

The remaining balance is at the disposal of the members.

Art. 19. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for the

amendment of the Articles of Incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need not to be

members and who are appointed by the general meeting which will specify their powers and remuneration.

Art. 20. If, and as long as one member holds all the corporate units, the company shall exist as a single member company,

pursuant to article 179 (2) of the law on Commercial Companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others,
of the same law are applicable.

Art. 21. For anything not dealt with in the present Articles of Incorporation, the members refer to the relevant

legislation.

<i>Transitory disposition

The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on December 31 

st

 , 2014.

<i>Subscription and payment

The share capital of the Company has been subscribed by Mrs Marie-Thérèse DISCRET, prenamed.
All the shares have been entirely paid up in cash, so that the company has now at its disposal the sum of EUR 12,500.

- (twelve thousand five hundred Euro) as was certified to the notary executing this deed.

120358

L

U X E M B O U R G

<i>Expenses

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its incorporation is approximately fixed at

950- EUR

<i>Resolutions of the sole shareholder

The appearing party, prenamed and representing the whole of the corporate capital, passed the following resolutions:
1) The Company shall be governed by one (1) manager.
2) Is appointed manager of the Company for an undetermined period:
- Mrs Marie-Thérèse DISCRET, prenamed, born on April 27 

th

 , 1959, in Longlier (B).

3) The address of the corporation is fixed at 35, rue Auguste Neyen, L-2233 Luxembourg.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above person

appearing, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same person appearing
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read and translated into the language of the person appearing, whom is known to the

notary by his surnames, Christian names, civil status and residences, said person appearing signed together with the
Notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède

L'an deux mil quatorze, le vingt-sept juin.
Par-devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg

A comparu:

Madame Marie-Thérèse DISCRET, gérante, demeurant à L-2311 Luxembourg, 153, avenue Pasteur.
Lequel comparant a prié le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité

limitée à constituer.

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et

les dispositions légales.

La société prend la dénomination de «Arithmex».

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision collective des

associés.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anor-
males.

Une telle décision n'aura d'effet sur la nationalité de la Société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée

à la connaissance des tiers par l'organe de la Société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet d'entreprendre dans le Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger tant pour son

propre compte que pour compte de tiers, toutes activités d'expertise comptable, de constitution, de domiciliation, de
tenue des livres comptables, d'administration et de gestion, de conseil fiscal, de toute société ou autre véhicule juridique
constitué au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger, y compris toutes activités de travaux d'analyse et de conseil
économique en ce qui concerne la situation et le fonctionnement des sociétés et autres véhicules juridiques Elle peut
rendre tous services se rattachant directement ou indirectement à de telles opérations, le tout dans le sens le plus large
autorisé par la loi.

La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts

de propriété immobiliers ou mobiliers en relation avec son objet ou pouvant en favoriser l'accomplissement.

Art. 5. Le capital social est fixé à 12.500 EUR (douze mille cinq cents euros) représenté par 100 (cent) parts sociales

d'une valeur nominale de 125 EUR (cent vingt-cinq euros) chacune.

Art. 6. Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par l'article 199

de la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 7. Chaque part donne droit à une fraction proportionnelle de l'actif social et des bénéfices.

120359

L

U X E M B O U R G

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés que moyennant l'agrément donné à la majorité des trois quarts des voix en assemblée générale ou autrement,
par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales ne peuvent être transmises
pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les
trois quarts des droits appartenant aux survivants. En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption.
Ils doivent l'exercer endéans trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé.

Art. 9. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l'incapacité, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé

unique ou de l'un des associés.

Art. 10. Les héritiers, créanciers ou autres ayants droit ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 11. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des

associés.

Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toute circonstance par la signature du gérant unique. En cas de pluralités

de gérants, les gérants ont, par les signatures conjointes de deux d'entre eux, les pouvoirs les plus étendus pour agir au
nom de la société dans toutes les circonstances. En cas d'empêchement temporaire des gérants, les affaires sociales
peuvent être gérées par deux associés, agissant conjointement.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle. Simples mandataires,

ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 13. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts

sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 15. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, le 31 décembre, la gérance établit les comptes annuels.

Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels.

Art. 18. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce

prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

Le solde est à la disposition des associés.

Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour

les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, associés

ou non, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

Art. 20. Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société

est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application.

Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2014.

<i>Souscription et paiement

Le capital social a été souscrit par Madame Marie-Thérèse DISCRET, prénommée.
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de

12.500 EUR (douze mille cinq cents euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, preuve en ayant
été donnée au notaire instrumentant.

<i>Evaluation

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ 950,- EUR.

<i>Décisions de l'associée unique

Ensuite le comparant, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1.- La société sera gérée par un (1) gérant.

120360

L

U X E M B O U R G

2.- Est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée:
Madame Marie-Thérèse DISCRET, prénommée, née le 27 avril 1959, à Longlier (B).
3.- Le siège social de la société est fixé au 35, rue Auguste Neyen, L-2233 Luxembourg.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par noms, prénoms, états et demeures,

le comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis de documenter le

présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte
français, le texte anglais fera foi.

Signé: M-T. DISCRET, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 01 juillet 2014. Relation: LAC/2014/30293. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros)

<i>Le Receveur ff.

 (signé): Carole FRISING.

POUR COPIE CONFORME, délivrée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg

Luxembourg, le 11 juillet 2014.

Référence de publication: 2014100708/195.
(140120601) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

Emerging Markets Taxi Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 184.675.

In the year two thousand and fourteen, on the eighteenth day of the month of June
Before the undersigned notary Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg);

THERE APPEARED:

1. Asia Internet Holding S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the

Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 177.038,
having its registered office at 7, avenue Pescatore, L-2324 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

being the holder of three thousand two hundred sixty-eight (3,268) common shares, and three thousand two hundred

sixty-eight (3,268) series A1 shares,

here represented by Ms Alix van der Wielen, maître en droit, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a

proxy, given in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 16 June 2014,

2. MKC Brillant Services GmbH, a limited liability company incorporated and existing under the laws of Germany,

registered with the commercial register at the local court of Charlottenburg, Germany, under no. HRB 139778 B, having
its registered office at Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Germany,

being the holder of eight thousand one hundred seventy (8,170) common shares, and eight thousand one hundred

seventy (8,170) series A2 shares,

here represented by Ms Alix van der Wielen, pre-named, by virtue of a proxy, given in Berlin, Germany, on 16 June

2014,

3. Aismare Lux Holdings S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the

Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 176.544,
having its registered office at 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, and having a
share capital of thirty thousand euros (EUR 30,000),

being the holder of four hundred eight (408) common shares, and four hundred eight (408) series A3 shares,
here represented by Ms Alix van der Wielen, pre-named, by virtue of a proxy, given in Munsbach, Grand Duchy of

Luxembourg, on 17 June 2014,

4. TEC Global Invest IX GmbH, a limited liability company incorporated and existing under the laws of Germany,

registered with Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg under number HRB 26061, having its registered office at
Wissollstrasse 5-43, 45478 Mülheim an der Ruhr,

being the holder of six hundred fifty-four (654) common shares, and six hundred fifty-four (654) series A4 shares,
here represented by Ms Alix van der Wielen, pre-named, by virtue of a proxy, given in Mülheim an der Ruhr, Germany,

on 17 June 2014,

5. Phenomen Ventures LP, an exempted Limited Partnership incorporated and existing under the laws of the Cayman

Islands, registration number OG - 66003, having its registered office at 89 Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman
KY1-9007, Cayman Islands, represented by its General Partner, Phenomen Ventures Management, an exempted company
incorporated and existing under the Law of the Cayman Islands, registered with Registry of Companies, Cayman Islands,

120361

L

U X E M B O U R G

under number OG-271195, having its registered address at 89 Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman KY1-9007,
Cayman Islands (hereinafter “Phenomen”), participating and voting only for purposes of agenda point 4 et seqq.,

becoming the holder of four thousand nine hundred two (4,902) series B shares,
here represented by Ms Alix van der Wielen, pre-named, by virtue of a proxy, given in Moscow, Russia, on 17 June

2014.

The said proxies, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary will remain annexed

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The parties 1., 2. 3. and 4. (the “Existing Shareholders”) are all the shareholders of Emerging Markets Taxi Holding S.à

r.l. (hereinafter the “Company”), a société à responsabilité limitée, having its registered office at 5, Heienhaff, L-1736
Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under
number B 184675, incorporated pursuant to a deed of the notary Henri HELLINCKX, residing in Luxembourg (Grand
Duchy of Luxembourg), on 7 February 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1066
on 26 April 2014. The articles of incorporation were amended for the last time pursuant to a deed of the said notary
Henri HELLINCKX on 6 June 2014, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The Existing Shareholders representing the entire share capital and having waived any notice requirement, the general

meeting of shareholders is regularly constituted and may validly deliberate on the following agenda whereby Phenomen
participates and votes for purpose of agenda point 4 et seqq. only:

<i>Agenda

1. Decision to create one (1) additional class of shares, referred to as the series B shares (the “Series B Shares”), and

to hence have six (6) classes of shares in total.

2. Acceptance of Phenomen Ventures LP, an exempted Limited Partnership, incorporated and existing under the laws

of the Cayman Islands, registration number OG - 66003, having its registered office at 89 Nexus Way, Camana Bay, Grand
Cayman KY1-9007, Cayman Islands, as new shareholder of the Company.

3. Increase of the Company’s share capital by an amount of four thousand nine hundred two euros (EUR 4,902) so as

to raise it from its current amount of twenty five thousand euros (EUR 25,000) up to twenty nine thousand nine hundred
two euros (EUR 29,902) by issuing four thousand nine hundred two (4,902) series B shares, having a nominal value of
one euro (EUR 1) each.

4. Subsequent amendment of article five point one (5.1) of the articles of association of the Company so that it shall

henceforth read as follows:

“ 5.1. The Company’s share capital is set at twenty nine thousand nine hundred two euros (EUR 29,902), represented

by (i) twelve thousand five hundred (12,500) common shares (the “Common Shares”), (ii) three thousand two hundred
and sixty eight (3,268) series A1 shares (the “Series A1 Shares”), (iii) eight thousand one hundred and seventy (8,170)
series A2 shares (the “Series A2 Shares”), (iv) four hundred eight (408) series A3 shares (the “Series A3 Shares”), (v) six
hundred fifty four (654) series A4 shares (the “Series A4 Shares”), and (vi) four thousand nine hundred two (4,902) series
B shares (the “Series B Shares”), with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each.”

5. Full restatement of the articles of association of the Company so that they shall henceforth read as follows:

“A. Name - Purpose - Duration - Registered office

Art. 1. Name. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name Emerging

Markets Taxi Holding S.à r.l. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 con-
cerning commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.

Art. 2. Purpose.
2.1 The object of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign

companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio in view of its realisation by sale, exchange or otherwise.

2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it

holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the
Company.

2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by

issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.

2.4 The purpose of the Company is also (i) the acquisition by purchase, registration or in any other manner as well as

the transfer by sale, exchange or otherwise of intellectual and industrial property rights, (ii) the granting of license on
such intellectual and industrial property rights, and (iii) the holding and the management of intellectual and industrial
property rights.

2.5 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities

which it considers useful for the accomplishment of these purposes.

120362

L

U X E M B O U R G

Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Art. 4. Registered Office.
4.1 The registered office of the Company is established in Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by decision of the board of managers. It

may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by resolution of the shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution

of the board of managers.

4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances

or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
traordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwiths-
tanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

B. Share capital - Shares

Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company’s share capital is set at twenty nine thousand nine hundred two euros (EUR 29,902), represented

by (i) twelve thousand five hundred (12,500) common shares (the “Common Shares”), (ii) three thousand two hundred
and sixty eight (3,268) series A1 shares (the “Series A1 Shares”), (iii) eight thousand one hundred and seventy (8,170)
series A2 shares (the “Series A2 Shares”), (iv) four hundred eight (408) series A3 shares (the “Series A3 Shares”), (v) six
hundred fifty four (654) series A4 shares (the “Series A4 Shares”), and (vi) four thousand nine hundred two (4,902) series
B shares (the “Series B Shares”), with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each.

5.2 The rights and obligations attached to the shares in the Company (the “Shares”) shall be identical except to the

extent otherwise provided by these articles of association or by the Law.

5.3 The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.4 Each of (i) MKC Brillant Services GmbH (“LIH”), (ii) Asia Internet Holding S.à r.l. (“AIH”), (iii) Aismare Lux Holdings

S.à r.l. (“Aismare”), (iv) TEC Global Invest IX GmbH (“TEC”) and (v) Phenomen Ventures LP (“Phenomen”, LIH, AIH,
Aismare, and TEC together the “Investors” and each an “Investor”) shall be entitled to subscribe for such amount of
further Shares to be issued in the course of a capital increase implementing an investment offer of a third party (being
neither a shareholder nor a company affiliated to a shareholder within the meaning of sections 15 et seqq. German Stock
Corporation Act (AktG) (a “Third Party Investor”) and which has been approved by the Advisory Board (a “Third Party
Investment”) - irrespective whether made by the Third Party Investor or one or more matching shareholders -required
to maintain up to its percentage ownership in the Company prior to such capital increase under the same terms and
conditions on which the Third Party Investment is based on. Each of (i) LIH, (ii) AIH, (iii) Aismare (iv) TEC and (v)
Phenomen shall inform the Company by binding declaration within three (3) weeks after it has been notified by the
Company regarding the Third Party Investment if (i) LIH, (ii) AIH, (iii) Aismare, (iv) TEC and (v) Phenomen intend/s to
exercise its/their respective right/s pursuant to the foregoing sentence of this Article 5.4. This Article 5.4 shall apply
mutatis mutandis in case any of the Investors subscribes for further Shares.

Art. 6. Shares.
6.1 The Company’s share capital is divided into Shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The Shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of

the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.

6.5 The Company may accept contributions without issuing shares or other securities in consideration and may allocate

such contributions to one or more distributable reserves. Decisions as to the use of any such distributable reserves are
to be taken by the shareholder(s) or the manager(s) as the case may be, subject to the Law and these articles of association.

Art. 7. Register of Shares - Transfer of Shares.
7.1 A register of Shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection

by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.

7.2 The Company will recognise only one holder per Share. In case a Share is owned by several persons, they shall

appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to that Share until such representative has been appointed.

120363

L

U X E M B O U R G

7.3 The Shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the Shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given

by shareholders holding at least three quarters of the share capital (a “Super Majority”) and subject to the provisions of
any shareholders’ agreement between the shareholders, if any, in particular, any rights of first refusal, rights of pre-
emption, tag-along rights, or drag-along rights contained in any shareholders’ agreement between the shareholders. To
the extent that such shareholder approval has been granted, an additional consent to the transfer of Shares is not required:

7.4.1 in any case of a transfer, sale, assignment or any other disposal of Shares by an Investor to a company affiliated

to such Investor within the meaning of sections 15 et seqq. German Stock Corporation Act (AktG) (each an “Affiliate”)

7.4.2 in case of the transfer, sale, assignment or any other disposal of Shares of one Investor to a company or entity

(x) which is directly or indirectly Controlling, Controlled by or under common Control with (i) this Investor or (ii) by
one or more direct or indirect shareholders of the respective Investor (each a “Controlled Company”), whereas “Con-
trol” or “Controlled” or “Controlling” shall mean the direct or indirect domination of the company or entity by way of
(a) managing the company or entity as managing shareholder, (b) holding the majority of Shares or (c) holding the majority
of voting rights by means of a contractual voting pool, or (y) in which the respective Investor or one or more shareholders
of such Investor has a direct or indirect majority shareholding;

7.4.3 in case of a transfer, sale, assignment or any other disposal of Shares by a Shareholder to the Company and/or

any of the Investors pursuant to a call -option under a vesting scheme.

7.5 To the extent a sale, transfer, assignment or any other disposal of Shares requires no additional consent of the

shareholders’ meeting pursuant to Article 7.4.1 through Article 7.4.3 above, neither duties to offer for sale, nor any rights
of first refusal, nor rights of pre-emption, nor tag-along rights, nor dragalong rights apply in favour of other shareholders.

7.6 Any sale, transfer, assignment or other disposal of Shares shall become effective towards the Company and third

parties through the notification thereof to, or upon the acceptance thereof by the Company in accordance with Article
1690 of the Civil Code.

7.7 In the event of death, the Shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject

to the approval of such transfer given by a Super Majority (which, for these purposes, shall exclude the Shares of the
deceased shareholder). Such approval is, however, not required in case the Shares are transferred either to parents,
descendants or the surviving spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.

Art. 8. Liquidation and Sale Preferences.
8.1 In case of (i) any transfer of at least fifty percent (50%) of all Shares in the Company, or a swap or a take-over of

the Company in an economically comparable way in a single or more related transactions or in close time proximity to
one another, (ii) transfer of at least 50% of the Company’s assets or business of the Company, in a single or more related
transactions, (iii) transfer of a material part of the Company’s intellectual property rights in a single or more related
transactions, (iv) the liquidation or de facto liquidation of the Company (in particular following an asset deal), or (v) any
sale or transfer of Shares in the Company either to third parties or other shareholders that would result in either more
than fifty percent (50%) of the share capital or more than fifty percent (50%) of the voting rights being owned by the
acquiring party/parties (change of control) as a result of one or more related acquisitions (each of the events described
in (i), (ii), (iii), (iv) or (v) is hereinafter referred to as a “Liquidity Event”), the proceeds (“Exit Proceeds”) - subject to
Article 8.2 and Article 8.3 below - will be distributed in accordance with Articles 8.4, 8.5 and 8.6 below to the shareholders
pro rata to their participation in the Liquidity Event.

8.2 On a first level (“First Level”) the holders of Series B Shares shall receive in preference to the remaining share-

holders an amount of EUR 3,060 per each Series B Share being subject to the Liquidity Event which equals the amount
of their respective total investment made in the Company per Series B Share (consisting of the nominal amount of the
Series B Shares acquired by that holder and any share premium and/or other capital contribution (account 115) paid by
that holder to the Company).

8.3 On a second level (“Second Level”), if and to the extent that the Exit Proceeds exceed the payments (Vorabzah-

lungen) to be made under § 8.2, the holders of Series A1 Shares, Series A2 Shares, Series A3 Shares and of the Series A4
Shares shall receive per Share of the respective share class the amount stipulated next to the relevant share class being
subject to the Liquidity Event in the following table:

Share Class

Amount

per Sha-

re in Eu-

ro

Series A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.65

Series A2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,562.87
Series A3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,128.45
Series A4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,117.21

8.4 After the payments on the First Level and on the Second Level have been made, the remaining Exit Proceeds shall

be allocated on a third level (“Third Level”) to all shareholders pro rata corresponding to their participation in the Liquidity
Event. Any amounts received by any shareholder on the First Level and/or Second Level shall reduce the amount to be

120364

L

U X E M B O U R G

allocated to such shareholder on the Third Level and shall be allocated subsequently pursuant to this Third Level provided
that no shareholder shall be obliged to repay any amount received on the First Level and/or Second Level. The allocation
at the Third Level shall be made until all Exit Proceeds have been distributed to the shareholders.

8.5 The preferred allocation of Exit Proceeds on the First Level and on the Second Level applies to each of the respective

Series A1 Shares, Series A2 Shares, Series A3 Shares, Series A4 Shares and Series B Shares as long as the respective
Investor has not yet received the full amount that is to be allocated to such Investor according to the First Level and/or
Second Level.

8.6 Irrespective of whether or not the transfer of Shares is made in one Liquidity Event or after the Liquidity Event in

one transaction or more transactions, no shareholder shall receive for the transfer of all of its Shares (and shall repay
any exceeding amount to the other shareholders) an amount exceeding the higher of (i) its share in the total Exit Proceeds
or  proceeds  pro  rata  to  the  Shares  transferred  on  a  common  equivalent  basis  or  (ii)  the  amount  allocated  to  such
shareholder on the First Level and/or Second Level from a subsequent transfer. All rights related to the liquidity preference
stipulated herein can only be exercised once.

Art. 9. Redemption of Shares.
9.1 The Company may redeem its own Shares. The voting rights of any of its Shares held by the Company are suspended,

for as long as they are held by the Company.

9.2 Shares of a shareholder may be redeemed without such shareholder’s consent, if:
9.2.1 insolvency proceedings are opened over the assets of the shareholder or the opening of insolvency proceedings

is rejected for lack of assets;

9.2.2 the Share of a shareholder is seized or enforcement proceedings are otherwise initiated against such Share and

such enforcement proceedings are not finally closed within two (2) months.

Upon receipt by such shareholder of the declaration of redemption sent by the board of managers, the Shares shall

automatically be redeemed without any further action being required. The present articles of association together with
the declaration of redemption constitute together a valid instrument in writing for the purposes of Article 190 of the
Law and the Company hereby acknowledges and accepts the transfer of the Shares in such case and undertakes to register
the transfer in its share register and to proceed with the relevant filings required by law.

9.3 If the Share in question is held by several persons, it is sufficient that the ground for redemption exists with respect

to one person; independently of this, several jointly entitled persons can only exercise the shareholders’ rights in a uniform
way through one jointly entitled person to be appointed for this purpose without undue delay after the joint entitlement
arises.

9.4 The board of managers may declare a redemption. The redemption declaration takes effect upon receipt of the

declaration by the shareholder concerned and if a respective shareholders’ resolution is adopted (except in case of Article
9.2 of these articles of association, in which no declaration by the shareholder concerned and no respective shareholders’
resolution is required).

Art. 10. Compensation for Redemption.
10.1 Redemption is made against compensation.
10.2 The compensation consists of a total amount equal to the market value of the redeemed Shares. The effective

date is the date before the redemption resolution.

10.3 The compensation for redemption shall be due and payable immediately upon redemption of the Shares.
10.4 The withdrawing shareholder shall not be entitled to request the Company to provide security for outstanding

amounts including interest.

10.5 In the event of dispute regarding the amount of the payable redemption compensation this is to determine by an

auditor as expert arbitrator who shall jointly be appointed by the shareholders. If no agreement is reached the expert
arbitrator shall be selected by the President of the Tribunal d’Arrondissement upon request of a shareholder or of the
Company. The decision of the expert arbitrator shall be binding. The costs of the expert opinion shall be borne by the
Company and the requesting shareholder in equal parts, the part allocated to such shareholder shall be set off with the
redemption price and the redemption price shall be reduced accordingly. The shareholder shall bear the remaining costs
in case the redemption price does not cover the costs allocated to the shareholder for the expert opinion.

Art. 11. Request of Assignment in Lieu of Redemption.
11.1 The Company may decide that, in lieu of redemption, the shareholder concerned shall transfer the Shares to a

person named by the Company (including another shareholder of the Company), including also partial redemption or
partial assignment of the Share to the Company or to a person named by the Company.

11.2 This Article 11 applies with the proviso that the compensation, as provided for in Article 10 of these articles of

association, for the Shares to be assigned is owed by the person acquiring the Shares and that the Company shall be liable
like a guarantor.

120365

L

U X E M B O U R G

C. Decisions of the shareholders

Art. 12. Collective Decisions of the Shareholders.
12.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these

articles of association.

12.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of Shares which he owns.
12.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise

conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case,
each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his
vote in writing.

12.4 The shareholders’ resolutions are passed in meetings. Unless mandatory law prescribes another form, they can

also be passed outside meetings in writing (including e-mail or fax) or telephone voting if such procedure is requested by
a shareholder and no other shareholder declares its dissent with the procedure within two (2) weeks towards the board
of managers of the Company in written form. If no dissent is declared within the two (2) weeks pursuant to the foregoing
sentence the votes of the shareholders which are not participating in the voting shall be deemed to be abstention from
voting. Written resolutions must be signed by each shareholder and the written record must be sent to each shareholder
without undue delay. Resolutions not passed in writing must be confirmed in writing. Such confirmation only has decla-
ratory significance.

12.5 Unless a notarial record is made of shareholders’ resolutions, a written record must be made of every resolution

passed at shareholders’ meetings (for purposes of proof, not as a precondition of validity) without undue delay, which
must state the date and form of the resolution passed, the content of the resolution and the votes cast. The written
record must be sent to each shareholder in writing without undue delay.

12.6 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of

shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by
the sole shareholder.

Art. 13. General Meetings of Shareholders.
13.1 Meetings of shareholders may be held at the registered office of the Company or at such place and time as may

be specified in the respective convening notices of meeting.

13.2  The  shareholders’  meeting  is  called  by  registered  letter  (registered  personal  delivery,  registered  delivery  or

registered letter with confirmation of receipt) to each shareholder, stating the place, date, time and agenda, with a period
of notice of at least four (4) weeks for ordinary shareholders’ meetings and at least two (2) weeks for extraordinary
shareholders’ meetings. The period of notice begins to run on the day following postage. The day of the shareholders’
meeting is not counted in the calculation of the period of notice.

13.3 If all shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived convening

requirements, the meeting may be held without prior notice.

13.4 Each shareholder is entitled to be accompanied or represented at the shareholders’ meeting by another share-

holder authorised by a written power of attorney or by a lawyer, tax advisor or auditor under a professional duty of
confidentiality.

13.5 Unless a notarial record is made of the negotiations of the shareholders’ meeting, a written record must be made

concerning the course of the meeting (for purposes of proof, not as a precondition of validity), which must state the place
and date of the meeting, the participants, the items on the agenda, the main content of the negotiations and the share-
holders’ resolutions. The written record must be signed by all shareholders present or represented in the shareholders’
meeting (for purposes of proof, not as a precondition of validity). Each shareholder must be sent a copy of the written
record.

Art. 14. Quorum and Vote.
14.1 Each shareholder is entitled to as many votes as it holds Shares.
14.2 A shareholders’ meeting only constitutes a quorum if at least 50% of the share capital is represented. Save for a

higher majority provided in these articles of association or by Law, collective decisions of the Company’s shareholders
are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share capital. If there is
no quorum, a new shareholders’ meeting with the same agenda must be called without undue delay in compliance with
Article 13.2. This shareholders’ meeting then shall constitute a quorum regardless of the share capital represented, if this
was pointed out in the notice calling the meeting and the decisions shall be taken at the majority of the votes cast.

Art. 15. Change of Nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous

consent.

Art. 16. Amendments of the Articles of Association. Any amendment of these articles of association requires the

approval of (i) a majority in number of shareholders (ii) who also constitute a Super Majority. Any amendment of these

120366

L

U X E M B O U R G

articles of association that materially or adversely affects the rights of the holders of Series A1 Shares, Series A2 Shares,
Series A3 Shares, Series A4 Shares and Series B Shares require the consent of all of the holders of such Shares.

Art. 17. Decisions Requiring Specific Majority.
17.1 Resolutions regarding the following subjects must be taken by a Super Majority and require the prior consent of

the Advisory Board:

17.1.1 disposition of all the Company’s assets, of a significant part of the Company’s assets or all or significant part of

assets of any direct or indirect subsidiary of the Company (including, among others, transfer of any and all of the intellectual
property rights), if such disposition is made on arm`s length terms;

17.1.2 resolution with respect to the liquidation of the Company;
17.1.3 amendment of these articles of association (including this Article 17) including the resolution with respect to

the merger, separation and transformation of the Company;

17.1.4 appropriation of the annual results; payments of profits to capital reserves or the carrying forward of such

profits to new accounts; increase or reduction of reserves (including but not limited to share premium and assimilated
premium) as well as capital increase from company funds;

17.1.5 conclusion, amendment and termination of intra-group agreements (Unternehmensverträge within the meaning

of sections 291 et seqq. of the German Stock Corporation Act (AktG));

17.1.6 conclusion, termination or amendment of sub-participations of any kind including silent partnerships in the

Company;

17.1.7 approval of the annual budget for each following year;
17.1.8 transfer of industrial property rights or documented know-how by the Company to a third party.
17.2 Resolutions regarding the following subjects must be taken by a Super Majority and also require the consent of

all of the Investors.

17.2.1 exclusion of subscription rights in case of capital increases;
17.2.2 acquisition of the Company’s own Shares, including redemption of Shares, with the exception of acquisitions in

accordance with Article 9.2 and transfers in accordance with Article 11.1 of these articles of association.

17.3 Whenever the capital of the Company is divided into different classes of shares the special rights and obligations

attached to any class may be varied or abrogated only with the unanimous consent in writing of the shareholders who
hold all the issued shares of that class.

17.4 Any changes in the decision making process (including the competence of meetings of shareholders, Advisory

Board  and  any  specific  majority  necessary  for  adoption  of  some  of  the  decisions)  of  the  Company  to  the  unilateral
disadvantage of any of the Investors shall not be made without such Investor’s consent. For the avoidance of doubt any
decrease of the number of votes or change of the voting rights of shareholders or managers necessary for adoption of
any decision will bring the unilateral disadvantage of the Investors.

D. Board of managers and advisory board

Art. 18. Powers of the Sole Manager - Composition and Powers of the Board of Managers.
18.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers

form a board of managers.

18.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not

expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of
association is to be construed as a reference to the “sole manager”.

18.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any

actions necessary or useful to fulfil the Company’s corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the
Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.

Art. 19. Election, Removal and Term of Office of Managers.
19.1 The manager(s) shall be elected by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration

and term of office.

19.2 The managers shall be elected and may be removed from office at any time, with or without cause, by a resolution

of the general meeting of shareholders.

19.3 The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two (2) different classes, being class A

managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant
shareholders resolutions and the managers be identified with respect to the class they belong.

Art. 20. Vacancy in the Office of a Manager.
20.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or

otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the replaced manager  by the remaining managers  until the  next  meeting  of shareholders  which  shall  resolve on the
permanent appointment, in compliance with the applicable legal provisions.

120367

L

U X E M B O U R G

20.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company’s sole manager, such vacancy must be filled without undue

delay by the general meeting of shareholders.

Art. 21. Convening Meetings of the Board of Managers.
21.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held

at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.

21.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers at least twenty-four (24)

hours in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such document being
sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined
in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.

21.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive

any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of
managers.

Art. 22. Management.
22.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not

need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

22.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may

appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any
such meeting.

22.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either

in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.

22.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other

means of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis
and allowing an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a
participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.

22.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or

represented at a meeting of the board of managers.

22.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,

if any, shall not have a casting vote. In the event however the general meeting of shareholders has appointed different
classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only
be validly taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which
may be represented).

22.7 The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in

writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be
the date of the last signature.

22.8 The managers shall require the consent of the Advisory Board for legal transactions and measures of the Company

specified below (no consent is required if such legal transactions and measures have been precisely defined and have in
advance been approved by an adopted budget with the consent of the shareholders’ meeting):

22.8.1 assumption of sureties, guarantees or similar liabilities in excess of an amount of five hundred thousand euro

(EUR 500,000.00) each;

22.8.2 futures transactions concerning currencies, securities and exchangetraded goods and rights as well as other

transactions with derivative financial instruments;

22.8.3 granting, introduction and amendment of pension commitments of any kind;
22.8.4 conclusion, amendment or termination of company collective agreements, works agreements (of substantial

importance) and of general guidelines regarding the company pension scheme;

22.8.5 institution and termination of legal disputes, in particular, arbitration proceedings involving a judicial amount in

controversy of more than five hundred thousand euro (EUR 500,000.00) in the individual case;

22.8.6 passing on of industrial property rights or know-how by the Company to a third party;
22.8.7 conclusion, termination or amendment of sub-participations of any kind including silent partnerships in the

Company;

22.8.8 transactions of the Company and its investment companies with affiliated legal entities and individuals as set

forth in any shareholders’ agreement between the shareholders; and

22.8.9 conclusion, amendment and termination of intra-group agreements (Unternehmensverträge within the meaning

of articles 291 et seqq. of the German Stock Corporation Act (AktG)).

120368

L

U X E M B O U R G

Resolutions regarding the introduction of an employee participation scheme require the consent of the Advisory Board.
22.9 If the consent is required as aforesaid for the acquisition, sale or encumbrance of objects, the consent is also

required for the contractual obligation relating thereto. The shareholders’ meeting may by resolution determine further
transactions and measures requiring the consent of the Advisory Board. The Advisory Board may give its consent also
in advance for certain groups and kinds of transactions and measures.

22.10 The shareholders may by shareholders’ resolution or by virtue of shareholders’ agreement adopt rules of pro-

cedure for the managers.

22.11 The management shall ensure that, as far as legally possible, the regulations in this Article 22 apply in the same

manner to all related companies in which the Company holds a majority interest, directly or indirectly, at present or in
the future.

Art. 23. Minutes of the Meeting of the Board of Managers Minutes of the Decisions of the Sole Manager.
23.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by

the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. In the event the general meeting of
shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers), such minutes
shall be signed by one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation). Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman,
if any, or by any two (2) managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of
managers (namely class A managers and class B managers), such copies or excerpts shall be signed by one (1) class A
manager and one (1) class B manager (including by way of representation).

23.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or

excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.

Art. 24. Dealing with Third Parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the

signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers;
in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A manager
and class B manager), the Company will only be validly bound by the joint signature of at least one (1) class A manager
and one (1) class B manager (including by way of representation) or (ii) by the joint signatures or the sole signature of
any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such
delegation.

Art. 25. Advisory Board.
25.1 The Company shall have an advisory board (the “Advisory Board”). It shall consist of six (6) voting members and

additional non-voting members (the “Observers”). The shareholders’ meeting may by way of unanimous shareholders’
resolution increase or decrease the number of members of the Advisory Board.

25.2 The shareholders’ meeting shall only adopt or amend the rules of procedure for the Advisory Board by way of a

unanimous shareholders’ resolution or by virtue of shareholders’ agreement.

25.3 Each of the Investors shall at all times be entitled to appoint a non-voting Observer to the Advisory Board who

shall be entitled to attend the meetings of the Advisory Board and receive any preparatory documents, meeting notices
and minutes of the Advisory Board at the same time as a voting member.

25.4 The voting members of the Advisory Board shall be nominated, withdrawn or replaced by each member’s res-

pective appointing shareholder by written notification towards the Company as follows:

25.4.1 two (2) voting members of the Advisory Board shall be nominated by the shareholder AIH in its sole discretion;
25.4.2 three (3) voting members of the Advisory Board shall be nominated by the shareholder LIH in its sole discretion;
25.4.3 one (1) voting member of the Advisory Board shall be nominated by the shareholder Phenomen in its sole

discretion.

Each voting member of the Advisory Board shall have one (1) vote.
25.5 The Advisory Board shall be competent for the granting of consents to any transactions and measures of the

managers which the shareholders’ meeting has made subject to the consent of the Advisory Board either (i) in these
articles of association, (ii) in the rules of procedure of the managers, (iii) by way of shareholders’ resolution or (iv) in any
shareholders’ agreement.

25.6 The remuneration of the members of the Advisory Board, if any, shall be determined by shareholders of the

Company by way of a unanimous shareholders’ resolution.

25.7 In addition to the consent requirements provided for in Article 22.8 and Article 22.9, the Advisory Board has a

consultative function and will not interfere in the management of the Company.

25.8 The Advisory Board is not a supervisory board within the meaning of article 60bis 11 et seq. of the Law.

120369

L

U X E M B O U R G

E. Audit and supervision

Art. 26. Auditor(s).
26.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company

shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.

26.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting

of shareholders.

26.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
26.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d’entreprises agréé

(s)) in accordance with Article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies’ register and the
accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.

26.5 An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its

approval.

F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends

Art. 27. Financial Year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end

on the thirty-first of December of the same year.

Art. 28. Annual Accounts and Allocation of Profits.
28.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of

the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.

28.2 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve.

This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten
per cent (10%) of the share capital of the Company.

28.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the

contributing shareholder agrees with such allocation.

28.4 In case of a share capital reduction, the Company’s legal reserve may be reduced in proportion so that it does

not exceed ten per cent (10%) of the share capital.

28.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the

remainder of the Company’s annual net profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.

28.6 Subject to Article 8, distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of Shares they

hold in the Company.

Art. 29. Interim Dividends Share Premium and Assimilated Premiums.
29.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared

by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed shall
be allocated where applicable in accordance with the provisions of Article 8 and may not exceed realized profits since
the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable reserves, but decreased by losses
carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles of association do not allow to be
distributed.

29.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the share-

holders subject to the provisions of the Law and these articles of association.

G. Liquidation

Art. 30. Liquidation. In the event of dissolution of the Company in accordance with Article 3.2 of these articles of

association, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting
of shareholders deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless other-
wise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realization of the assets and payment of the
liabilities of the Company.

H. Final clause - Governing law

Art. 31. Governing Law.
31.1 All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the Law and any

shareholders’ agreement which may be entered into from time to time between the shareholders and the Company, and
which may supplement certain provisions of these articles. Where any matter contained in these articles conflicts with
the provisions of any shareholders’ agreement, such shareholders’ agreement shall prevail inter partes and to the extent
permitted by Luxembourg law.

31.2 These articles are worded in English followed by a German translation; in case of divergence between the English

and the German text, the English version shall prevail.”

6. Miscellaneous.

120370

L

U X E M B O U R G

Having duly considered each item of the agenda, the general meeting of shareholders unanimously takes the following

resolutions:

<i>First resolution

The general meeting of shareholders decides to create one (1) additional class of shares, referred to as the series B

shares (the “Series B Shares”), and to hence have six (6) classes of shares in total.

<i>Second resolution

The general meeting of shareholders accepts Phenomen, aforementioned, as new shareholder of the Company.

<i>Third resolution

The general meeting of shareholders resolves to increase the Company’s share capital by an amount of four thousand

nine hundred two euros (EUR 4,902) so as to raise it from its current amount of twenty five thousand euros (EUR 25,000)
up to twenty nine thousand nine hundred two euros (EUR 29,902) by issuing four thousand nine hundred two (4,902)
series B shares, having a nominal value of one euro (EUR 1) each.

<i>Subscription

Four thousand nine hundred two (4,902) Series B Shares have been duly subscribed by Phenomen, aforementioned,

here represented as aforementioned, for the price of four thousand nine hundred two euros (EUR 4,902).

<i>Payment

The four thousand nine hundred two (4,902) Series B Shares subscribed by Phenomen, aforementioned, have been

entirely paid up through a contribution in cash in an amount of four thousand nine hundred two euros (EUR 4,902).

The proof of the existence and of the value of the above contribution has been produced to the undersigned notary

by a blocking certificate.

The contribution in the amount of four thousand nine hundred two euros (EUR 4,902) is entirely allocated to the

share capital.

<i>Fourth resolution

The general meeting of shareholders resolves to amend article five point one (5.1) of the articles of association of the

Company so that it shall henceforth read as follows:

“ 5.1. The Company’s share capital is set at twenty nine thousand nine hundred two euros (EUR 29,902), represented

by (i) twelve thousand five hundred (12,500) common shares (the “Common Shares”), (ii) three thousand two hundred
and sixty eight (3,268) series A1 shares (the “Series A1 Shares”), (iii) eight thousand one hundred and seventy (8,170)
series A2 shares (the “Series A2 Shares”), (iv) four hundred eight (408) series A3 shares (the “Series A3 Shares”), (v) six
hundred fifty four (654) series A4 shares (the “Series A4 Shares”), and (vi) four thousand nine hundred two (4,902) series
B shares (the “Series B Shares”), with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each.”

<i>Fifth resolution

Inter alia as a result of the foregoing, the general meeting of shareholders unanimously resolves to fully restate the

articles of association of the Company which shall henceforth read as set out in the agenda of the present deed.

There being no further business, the meeting is closed.

<i>Costs and expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are

estimated at approximately one thousand six hundred euro (EUR 1,600.-).

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,

the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing party and
in case of divergence between the English and the German text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name

and residence, the said proxyholder signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausendvierzehn, am achtzehnten Tag des MonatsJuni;
Vor dem unterzeichneten Notar Carlo WERSANDT, mit dem Amtssitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg);

SIND ERSCHIENEN:

120371

L

U X E M B O U R G

1. Asia Internet Holding S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) gegründet

und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesell-
schaftsregister  unter  der  Nummer  B  177.038,  mit  Sitz  in  7,  avenue  Pescatore,  L-2324  Luxemburg,  Großherzogtum
Luxemburg,

Inhaber von dreitausendzweihundertachtundsechzig (3.268) Stammanteilen und von dreitausendzweihundertachtund-

sechzig (3.268) Anteilen der Serie A1,

hier vertreten durch Frau Alix van der Wielen, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht,

ausgestellt in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, am 16. Juni 2014,

2. MKC Brillant Services GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet und bestehend unter deutschem

Recht, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland, unter der Nummer HRB 139778
B, mit Sitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Deutschland,

Inhaber von achttausendeinhundertsiebzig (8.170) Stammanteilen und von achttausendeinhundertsiebzig (8.170) An-

teilen der Serie A2,

hier vertreten durch Frau Alix van der Wielen, vorgenannt, gemäß einer Vollmacht vom 16. Juni 2014, ausgestellt in

Berlin, Deutschland,

3. Aismare Lux Holdings S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) gegründet

und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesell-
schaftsregister unter der Nummer B 176.544, mit Sitz in 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Großherzogtum
Luxemburg, mit einem Gesellschaftskapital in Höhe von dreißigtausend Euro (EUR 30.000),

Inhaber von vierhundertacht (408) Stammanteilen und von vierhundertacht (408) Anteilen der Serie A3,
hier vertreten durch Frau Alix van der Wielen, vorgenannt, gemäß einer Vollmacht, ausgestellt in Munsbach, Groß-

herzogtum Luxemburg, am 17. Juni 2014,

4. TEC Global Invest IX GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet und bestehend unter deutschem

Recht, eingetragen im Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg unter der Nummer HRB 26061, mit Sitz in Wissoll-
straße 5-43, 45478 Mülheim an der Ruhr,

Inhaber von sechshundertvierundfünfzig (654) Stammanteilen und von sechshundertvierundfünfzig (654) Anteilen der

Serie A4,

hier vertreten durch Frau Alix van der Wielen, vorgenannt, gemäß einer Vollmacht vom 17. Juni 2014, ausgestellt in

Mülheim an der Ruhr, Deutschland,

5. Phenomen Ventures LP, ein exempted Limited Partnership gegründet und bestehend unter dem Recht der Kai-

maninseln (Cayman Islands), mit der Eintragungsnummer OG - 66003, mit Sitz in 89 Nexus Way, Camana Bay, Grand
Cayman KY1-9007, Cayman Islands, vertreten durch ihren unbeschränkt haftenden Gesellschafter (General Partner),
Phenomen Ventures Management, eine Gesellschaft (exempted company) gegründet und bestehend unter dem Recht der
Kaimaninseln, eingetragen im Registry of Companies, Cayman Islands, unter der Nummer OG-271195, mit Sitz in 89
Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman KY1-9007, Cayman Islands, („Phenomen“), ausschließlich für die Punkte 4 ff.
der Tagesordnung teilnahme- und stimmberechtigt,

zukünftiger Inhaber von viertausendneunhundertzwei (4.902) Anteilen der Serie B,
hier vertreten durch Frau Alix van der Wielen, vorgenannt, gemäß einer Vollmacht vom 17. Juni 2014, ausgestellt in

Moskau, Rußland,

Besagte Vollmachten, welche von der Bevollmächtigten der erschienenen Parteien und dem Notar ne varietur para-

phiert wurden, werden der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.

Die Parteien 1., 2., 3. und 4. (die „Bestehenden Gesellschafter“) sind alle Gesellschafter der Emerging Markets Taxi

Holding S.à r.l. (die „Gesellschaft”), einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), mit Sitz
in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesell-
schaftsregister unter der Nummer B 184675, gegründet am 7. Februar 2014 gemäß einer Urkunde des Notars Henri
HELLINCKX, mit dem Amtssitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg), welche am 26. April 2014 im Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1066 veröffentlicht wurde. Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt am
6. Juni 2014 gemäß einer Urkunde des vorgenannten Notars Henri HELLINCKX geändert, welche noch nicht im Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht wurde.

Da die Bestehenden Gesellschafter das gesamte Gesellschaftskapital vertreten und auf jegliche Ladungsformalitäten

verzichtet haben, ist die Gesellschafterversammlung ordnungsgemäß zusammengekommen und kann wirksam über die
folgende Tagesordnung verhandeln, wobei Phenomen ausschließlich für die Punkte 4 ff. der Tagesordnung teilnahme- und
stimmberechtigt ist:

<i>Tagesordnung

1. Beschluss bezüglich der Schaffung einer (1) weiteren Klasse von Anteilen, welche als Anteile der Serie B bezeichnet

werden (die „Anteile der Serie B“), wodurch nunmehr insgesamt sechs (6) Anteilsklassen bestehen.

120372

L

U X E M B O U R G

2. Aufnahme von Phenomen Ventures LP, einem exempted Limited Partnership gegründet und bestehend unter dem

Recht der Kaimaninseln, mit der Eintragungsnummer OG - 66003, mit Sitz in 89 Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman
KY1-9007, Cayman Islands, als neuer Gesellschafter der Gesellschaft.

3. Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von fünfundzwanzigtausend Euro

(EUR 25.000) um einen Betrag von viertausendneunhundertzwei Euro (EUR 4.902) auf einen Betrag von neunundzwan-
zigtausendneunhundertzwei Euro (EUR 29.902) durch die Ausgabe von viertausendneunhundertzwei (4.902) Anteilen der
Serie B mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1).

4. Dementsprechende Änderung des Artikels 5.1 der Satzung der Gesellschaft, welcher nunmehr wie folgt lautet:

„ 5.1. Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt neunundzwanzigtausendneunhundertzwei Euro (EUR 29.902),

bestehend  aus  (i)  zwölftausendfünfhundert  (12.500)  Stammanteilen  (die  „Stammanteile”),  (ii)  dreitausendzweihunder-
tachtundsechzig (3.268) Anteilen der Serie A1 (die „Anteile der Serie A1“), (iii) achttausendeinhundertsiebzig (8.170)
Anteilen der Serie A2 (die „Anteile der Serie A2“), (iv) vierhundertacht (408) Anteilen der Serie A3 (die „Anteile der
Serie A3“), (v) sechshundertvierundfünfzig (654) Anteilen der Serie A4 (die „Anteile der Serie A4“) und (vi) viertausend-
neunhundertzwei (4.902) Anteilen der Serie B (die „Anteile der Serie B“), mit einem Nominalwert von je einem Euro
(EUR 1).“

5. Gänzliche Neufassung der Satzung der Gesellschaft, welche nunmehr wie folgt lautet:

„A. Name - Zweck - Dauer - Sitz

Art. 1. Name. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen

„Emerging Markets Taxi Holding S.à r.l.“ (die „Gesellschaft”), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August
1915 über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Ge-

sellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder
auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kontrolle
und Entwicklung ihrer Beteiligungen, im Hinblick auf deren Verwertung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Art.

2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder

Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören, Garantien geben,
Sicherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.

2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere

durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren oder
Schuldtiteln, Schuldverschreibungen und Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheinen bzw. Wertpapie-
ren.

2.4 Der Zweck der Gesellschaft ist auch (i) der Erwerb durch Kauf, Eintragung oder in jeder anderen Form, sowie die

Übertragung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Art von geistigem Eigentum und gewerblichen Schutzrechten, (ii)
die Erteilung von Lizenzen bezüglich solchem geistigem Eigentum und solcher gewerblicher Schutzrechte, und (iii) das
Innehaben und die Verwaltung von geistigem Eigentum und gewerblichen Schutzrechten.

2.5 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur sowie

solche, welche geistiges Eigentum oder Grundeigentum betreffen, vornehmen, die ihr zur Erreichung dieser Zwecke
förderlich erscheinen.

Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden,

welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird.

Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Rates der Geschäftsführer

verlegt werden. Durch einen Gesellschafterbeschluss, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und
Weise gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer im

Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.

4.4 Sollte der Rat der Geschäftsführer entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale

Entwicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an
ihrem  Gesellschaftssitz  beeinträchtigen  könnten,  so  kann  der  Gesellschaftssitz  bis  zur  endgültigen  Beendigung  dieser
außergewöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben
keine Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes
eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.

120373

L

U X E M B O U R G

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt neunundzwanzigtausendneunhundertzwei Euro (EUR 29.902),

bestehend  aus  (i)  zwölftausendfünfhundert  (12.500)  Stammanteilen  (die  „Stammanteile”),  (ii)  dreitausendzweihunder-
tachtundsechzig (3.268) Anteilen der Serie A1 (die „Anteile der Serie A1“), (iii) achttausendeinhundertsiebzig (8.170)
Anteilen der Serie A2 (die „Anteile der Serie A2“), (iv) vierhundertacht (408) Anteilen der Serie A3 (die „Anteile der
Serie A3“), (v) sechshundertvierundfünfzig (654) Anteilen der Serie A4 (die „Anteile der Serie A4“) und (vi) viertausend-
neunhundertzwei (4.902) Anteilen der Serie B (die „Anteile der Serie B“), mit einem Nominalwert von je einem Euro
(EUR 1).

5.2 Die mit den Anteilen der Gesellschaft (die „Anteile“) verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn,

es wird in dieser Satzung oder durch das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.

5.3 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-

zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.

5.4 Jede der Gesellschaften (i) MKC Brillant Services GmbH („LIH“), (ii) Asia Internet Holding S.à r.l. („AIH“), (iii)

Aismare Lux Holdings S.à r.l. („Aismare“), (iv) TEC Global Invest IX GmbH („TEC“) und (v) Phenomen Ventures LP
(„Phenomen“, LIH, AIH, Aismare und TEC gemeinschaftlich die „Investoren“ und jeweils ein „Investor“) ist zur Zeichnung
einer Anzahl weiterer bei einer Kapitalerhöhung ausgegebener Anteile berechtigt, wodurch ein Investmentangebot eines
Dritten umgesetzt wird (bei dem es sich weder um einen Gesellschafter, noch um eine mit einem Gesellschafter ver-
bundene Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG) (ein „Drittinvestor“) handelt), der vom
Beirat zugestimmt wurde (eine „Investition eines Dritten“) - unabhängig davon, ob diese vom Drittinvestor oder von
einem oder mehreren vergleichbaren Gesellschaftern erfolgte -und die zur Erhaltung der Beteiligungsquote an der Ge-
sellschaft vor einer solchen Kapitalerhöhung erforderlich ist, und dies zu denselben Bedingungen, wie bei einer Investition
eines Dritten. Jede der Gesellschaften (i) LIH, (ii) AIH, (iii) Aismare, (iv) TEC und (v) Phenomen hat die Gesellschaft durch
eine verbindliche Erklärung innerhalb von drei (3) Wochen nach Ankündigung der Investition eines Dritten durch die
Gesellschaft darüber zu unterrichten, ob (i) LIH, (ii) AIH, (iii) Aismare, (iv) TEC und (v) Phenomen ihr(e) jeweilige(s)/(n)
Recht(e) gemäß des vorstehenden Satzes dieses Artikels 5.4 ausüben möchte. Dieser Artikel 5.4 ist für den Fall, dass einer
der Investoren weitere Anteile zeichnet, entsprechend anwendbar.

Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit jeweils dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht über-

schreiten darf.

6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs oder die Insol-

venz oder ein vergleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.

6.5 Die Gesellschaft kann Einlagen ohne Ausgabe von Anteilen oder anderen Sicherheiten als Gegenleistung annehmen

und diese einer oder mehreren ausschüttbaren Rücklagen zuführen. Entscheidungen bezüglich der Verwendung solcher
ausschüttbarer Rücklagen werden gegebenenfalls von dem(den) Gesellschafter(n) oder Geschäftsführer(n) unter Berück-
sichtigung des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung getroffen.

Art. 7. Anteilsregister - Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden

kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.

7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten

wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft
ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.

7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.
7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern, die

mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals (eine „Qualifizierte Mehrheit“) halten und vorbehaltlich der Bestim-
mungen von Gesellschaftervereinbarungen zwischen den Gesellschaftern, sofern vorhanden, insbesondere vorbehaltlich
Vorkaufsrechten,  Bezugsrechten,  Mitverkaufsrechten-  oder  Pflichten  aus  Gesellschaftervereinbarungen  zwischen  den
Gesellschaftern übertragen werden. Sofern eine solche Zustimmung der Gesellschafter erteilt wurde, ist eine weitere
Einwilligung zur Übertragung von Anteilen nicht erforderlich:

7.4.1 bei einer Übertragung, einem Verkauf, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen durch

einen Investor an eine mit dem betreffenden Investor verbundene Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. des deutschen
Aktiengesetzes (AktG) (jeweils eine „Verbundene Gesellschaft“);

7.4.2 bei einer Übertragung, einem Verkauf, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen eines

Investors an eine Gesellschaft oder ein Unternehmen, (x) welche/s direkt oder indirekt (i) diesen Investor oder (ii) einen

120374

L

U X E M B O U R G

oder mehrere direkte oder indirekte Gesellschafter des betreffenden Investors (jeweils eine „Kontrollierte Gesellschaft“)
Kontrolliert, von diesem Kontrolliert Wird, oder unter der gemeinsamen Kontrolle von diesem steht, wobei die Worte
„Kontrolle“ oder „Kontrolliert Wird“ oder „Kontrolliert“ die direkte oder indirekte Beherrschung der Gesellschaft oder
des Unternehmens bezeichnet, durch (a) die Leitung der Gesellschaft oder des Unternehmens durch einen geschäfts-
führenden Gesellschafter, (b) das Halten der Mehrheit der Anteile oder (c) das Halten der Mehrheit der Stimmrechte
durch eine vertragliche Stimmvereinbarung, oder (y) in welcher/m der betreffende Investor oder ein oder mehrere Ge-
sellschafter dieses Investors eine direkte oder indirekte Mehrheitsbeteiligung haben;

7.4.3 bei einer Übertragung, einem Verkauf, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen durch

einen Gesellschafter an die Gesellschaft und/oder einen beliebigen Investor gemäß einer Call-Option im Zusammenhang
mit einer Vesting-Regelung.

7.5 Sofern ein Verkauf, eine Übertragung, eine Abtretung oder eine andere Veräußerung von Anteilen keiner weiteren

Zustimmung als der der Gesellschafterversammlung gemäß Artikel 7.4.1 bis 7.4.3 bedarf, gelten weder Verpflichtungen
zu Verkaufsangeboten, noch Vorkaufsrechte, Bezugsrechte oder Mitverkaufsrechte- oder Pflichten zugunsten anderer
Gesellschafter.

7.6 Ein Verkauf, eine Übertragung, eine Abtretung oder eine andere Veräußerung von Anteilen wird gegenüber der

Gesellschaft und Dritten gemäß Artikel 1690 des Code Civil wirksam, nachdem die Gesellschaft darüber in Kenntnis
gesetzt wurde oder diesem/dieser zugestimmt hat.

7.7 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters nur an neue Gesellschafter übertragen werden,

wenn eine Qualifizierte Mehrheit einer solchen Übertragung zugestimmt hat (wobei die Anteile des verstorbenen Ge-
sellschafters für diese Zwecke nicht berücksichtigt werden). Eine derartige Zustimmung ist jedoch nicht erforderlich,
wenn die Anteile an Eltern, Nachkommen oder den/die überlebende/n Ehepartner/in oder jeden anderen gesetzlichen
Erben des verstorbenen Gesellschafters übertragen werden.

Art. 8. Liquidations- und Verkaufspräferenzen.
8.1 Im Falle (i) einer Übertragung von mindestens fünfzig Prozent (50%) aller Anteile an der Gesellschaft oder eines

Tausches oder einer Übernahme der Gesellschaft in wirtschaftlich vergleichbarer Weise in einer oder mehreren zusam-
mengehörenden Transaktionen oder in zeitlicher Nähe zueinander, (ii) einer Übertragung von mindestens fünfzig Prozent
(50%) des Vermögens oder der Geschäfte der Gesellschaft in einer oder mehreren zusammengehörenden Transaktionen,
(iii) einer Übertragung eines wesentlichen Teils von Rechten im Bezug auf geistiges Eigentum der Gesellschaft in einer
oder mehreren zusammengehörenden Transaktionen, (iv) der Liquidation oder der de facto-Liquidation der Gesellschaft
(insbesondere nach einem Asset Deal), oder (v) eines Verkaufs oder einer Übertragung von Anteilen an der Gesellschaft
entweder an Dritte oder an andere Gesellschafter, was dazu führen würde, dass entweder mehr als fünfzig Prozent (50%)
des Gesellschaftskapitals oder mehr als fünfzig Prozent (50%) der Stimmrechte im Besitz der erwerbenden Partei bzw.
Parteien wären (change of control), als Ergebnis einer oder mehrerer verbundener Akquisitionen, (wobei jeder der unter
(i), (ii), (iii), (iv) und (v) beschriebenen Fälle im Folgenden als „Liquiditätsereignis“ bezeichnet wird), werden die Erlöse
(„Exiterlöse“) -vorbehaltlich der Artikel 8.2 und 8.3 - im Einklang mit den Artikeln 8.4, 8.5 und 8.6 auf einer pro rata-
Basis entsprechend ihrer Beteiligung am Liquiditätsereignis an die Gesellschafter verteilt.

8.2 Auf einer ersten Ebene („Erste Ebene”) erhalten die Inhaber von Anteilen der Serie B vorzugsweise im Verhältnis

zu den übrigen Gesellschaftern für jeden vom Liquiditätsereignis betroffenen Anteil der Serie B einen Betrag in Höhe von
EUR 3.060, welcher pro Anteil der Serie B dem Betrag ihrer jeweiligen Gesamtinvestition in die Gesellschaft entspricht
(bestehend aus dem Nominalbetrag der von diesem Inhaber erworbenen Anteile der Serie B und dem Agio und/oder
anderen Kapitaleinlage (Konto 115 des Standardisierten Luxemburgischen Kontenplans), die von diesem Inhaber an die
Gesellschaft gezahlt wurde).

8.3 Wenn und soweit die Exiterlöse die gemäß § 8.2 zu leistenden Vorabzahlungen übersteigen, erhalten die Inhaber

der Anteile der Serie A1, der Anteile der Serie A2, der Anteile der Serie A3 und der Anteile der Serie A4 auf einer
zweiten Ebene („Zweite Ebene”) pro Anteil der jeweiligen Anteilsklasse den in der folgenden Tabelle neben der ent-
sprechenden vom Liquiditätsereignis betroffenen Anteilsklasse festgelegten Betrag:

Anteilsklasse

Betrag

pro

Anteil in

Euro

Serie A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8,65

Serie A2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.562,87
Serie A3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.128,45
Serie A4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.117,21

8.4 Nachdem die Zahlungen auf der Ersten Ebene und auf der Zweiten Ebene geleistet wurden, werden die übrigen

Exiterlöse auf einer dritten Ebene („Dritte Ebene“) an alle Gesellschafter auf einer pro rata-Basis entsprechend ihrer
Beteiligung am Liquiditätsereignis verteilt. Sämtliche von einem Gesellschafter auf der Ersten und/oder Zweiten Ebene
erhaltenen Beträge mindern den von diesem Gesellschafter zu erhaltenden Betrag auf der Dritten Ebene und werden
anschließend entsprechend dieser Dritten Ebene zugeteilt, mit der Maßgabe, dass kein Gesellschafter zur Rückzahlung

120375

L

U X E M B O U R G

eines auf der Ersten und/oder Zweiten Ebene erhaltenen Betrags verpflichtet ist. Die Zuteilung auf der Dritten Ebene
erfolgt solange, bis alle Exiterlöse an die Gesellschafter verteilt wurden.

8.5 Die bevorzugte Zuteilung der Exiterlöse auf der Ersten Ebene und auf der Zweiten Ebene gilt für jeden der jeweiligen

Anteile der Serie A1, Anteile der Serie A2, Anteile der Serie A3, Anteile der Serie A4 und Anteile der Serie B solange,
wie der jeweilige Investor den Gesamtbetrag, welcher diesem Investor gemäß der Ersten und/oder Zweiten Ebene zu-
zuteilen ist, noch nicht erhalten hat.

8.6 Unabhängig davon, ob die Übertragung von Anteilen während eines Liquiditätsereignisses oder danach in einer

oder mehreren Transaktionen erfolgt oder nicht, hat kein Gesellschafter für die Übertragung all seiner Anteile einen
Betrag zu erhalten (und übersteigende Beträge an die anderen Gesellschafter zurückzuzahlen), der höher ist, (i) als sein
Anteil an der Gesamtheit der Exiterlöse oder Erlöse auf einer pro rata-Basis zu den Anteilen, die auf einer gemeinsamen
und gleichwertigen Basis übertragen wurden, oder (ii) als der Betrag, der diesem Gesellschafter auf der Ersten und/oder
Zweiten Ebene aus einer späteren Übertragung zugeteilt wurde. Sämtliche mit der hierin festgelegten Liquiditätspräferenz
verbundenen Rechte können nur einmal ausgeübt werden.

Art. 9. Rückkauf von Anteilen.
9.1 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen. Die Stimmrechte der von der Gesellschaft gehaltenen

Anteile werden so lange ausgesetzt, wie die Anteile von der Gesellschaft gehalten werden.

9.2 Anteile eines Gesellschafters können ohne Zustimmung eines solchen zurückgekauft werden, wenn:
9.2.1 ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des Gesellschafters eröffnet wird oder die Eröffnung eines Insolvenz-

verfahrens mangels Masse abgelehnt wird;

9.2.2 der Anteil des Gesellschafters gepfändet wurde oder Vollstreckungsverfahren anderweitig gegen diesen Anteil

eingeleitet wurden und diese Verfahren nicht innerhalb von zwei (2) Monaten vollständig eingestellt sind.

Mit Erhalt durch den Gesellschafter der vom Rat der Geschäftsführer gesendeten Rückkaufserklärung sind die Anteile

automatisch zurückgekauft, ohne dass es einer weiteren Handlung bedarf. Die vorliegende Satzung stellt gemeinsam mit
der Rückkaufserklärung ein gültiges Dokument im Sinne des Artikels 190 des Gesetzes von 1915 dar und die Gesellschaft
bestätigt hiermit die Kenntnisnahme der Übertragung der Anteile, akzeptiert diese und verpflichtet sich zur Eintragung
dieser Übertragung in ihrem Anteilsregister und zur entsprechenden gesetzlich geforderten Hinterlegung für diesen Fall.

9.3 Wird der besagte Anteil von mehreren Personen gehalten, ist das Vorliegen eines Grundes zum Rückkauf in Bezug

auf eine Person ausreichend; unabhängig davon können mehrere gemeinschaftlich berechtigte Personen die Gesellschaf-
terrechte nur dann und einheitlich ausüben, wenn eine der gemeinschaftlich berechtigten Personen unverzüglich nach
Eintritt der gemeinschaftlichen Berechtigung zu diesem Zwecke ernannt wird.

9.4 Ein Rückkauf kann durch den Rat der Geschäftsführer erklärt werden. Die Rückkaufserklärung wird wirksam, sobald

der betreffende Gesellschafter die Erklärung erhält und ein entsprechender Gesellschafterbeschluss gefasst wird (außer
im Falle von Artikel 9.2 dieser Satzung, in welchem keine Erklärung des Gesellschafters und kein entsprechender Gesell-
schafterbeschluss erforderlich sind).

Art. 10. Ausgleichszahlung für den Rückkauf.
10.1 Der Rückkauf erfolgt gegen eine Ausgleichszahlung.
10.2 Die Ausgleichszahlung besteht aus einem Gesamtbetrag, welcher dem Marktwert der zurückgekauften Anteile

entspricht. Als Stichtag gilt der Tag vor dem Rückkaufsbeschluss.

10.3 Die Ausgleichszahlung für den Rückkauf ist unmittelbar mit dem Rückkauf der Anteile fällig und zahlbar.
10.4 Der ausscheidende Gesellschafter ist nicht dazu befugt, von der Gesellschaft Sicherheiten für ausstehende Beträge

zuzüglich Zinsen zu verlangen.

10.5 Bei Streitigkeiten hinsichtlich des Betrags der zu zahlenden Ausgleichszahlung ist dieser Betrag von einem Wirt-

schaftsprüfer  in  der  Eigenschaft  als  Schiedsgutachter,  der  von  den  Gesellschaftern  gemeinschaftlich  ernannt  wird,
festzulegen. Wird über die Ernennung des Schiedsgutachters keine Einigung erzielt, so wird dieser auf Ersuchen eines
Gesellschafters oder der Gesellschaft vom Vorsitzenden des Bezirksgerichts (Tribunal d’Arrondissement) bestimmt. Die
Entscheidung des Schiedsgutachters ist bindend. Die Kosten für das Gutachten werden von der Gesellschaft und dem
betreffenden Gesellschafter zu gleichen Teilen getragen, wobei der vom Gesellschafter zu tragende Teil mit dem Rück-
kaufspreis verrechnet und der Rückkaufspreis dementsprechend herabgesetzt wird. Der Gesellschafter hat die übrigen
Kosten zu tragen, sofern der Rückkaufspreis die dem Gesellschafter zugewiesenen Kosten für das Gutachten nicht deckt.

Art. 11. Abtretung anstelle von Rückkauf.
11.1 Die Gesellschaft kann entscheiden, dass der betreffende Gesellschafter anstelle des Rückkaufs die Anteile an eine

von der Gesellschaft benannte Person (einschließlich eines anderen Gesellschafters) zu übertragen hat, auch im Falle eines
Teilrückkaufs oder einer Teilabtretung der Anteile an die Gesellschaft oder an eine von der Gesellschaft benannte Person.

11.2 Der vorliegende Artikel 11 gilt mit der Maßgabe, dass, wie in Artikel 10 dieser Satzung vorgesehen, die Aus-

gleichszahlung  für  die  abzutretenden  Anteile  durch  die  die  Anteile  erwerbende  Person  geschuldet  ist  und  dass  die
Gesellschaft als Garant haftet.

120376

L

U X E M B O U R G

C. Entscheidungen der Gesellschafter

Art. 12. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
12.1 Die Gesellschafterversammlung ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch das Gesetz und diese Satzung

ausdrücklich vorbehalten sind.

12.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.
12.3  Falls  und  solange  die  Gesellschaft  nicht  mehr  als  fünfundzwanzig  (25)  Gesellschafter  hat,  dürfen  gemeinsame

Entscheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung vorbehalten wären, schriftlich gefasst werden. In die-
sem Fall erhält jeder Gesellschafter den Text der zu fassenden Beschlüsse oder Entscheidungen in ausformulierter Form
und übt sein Stimmrecht schriftlich aus.

12.4 Gesellschafterbeschlüsse werden in Versammlungen gefasst. Sofern nicht zwingende gesetzliche Vorschriften eine

andere Form vorschreiben, können sie auch außerhalb von Versammlungen in schriftlicher Form (einschließlich E-Mail
oder Fax) oder durch telefonische Abstimmung gefasst werden, sofern ein solches Verfahren von einem Gesellschafter
ersucht wird und kein anderer Gesellschafter innerhalb von zwei (2) Wochen in schriftlicher Form Widerspruch gegen
dieses Verfahren gegenüber dem Rat der Geschäftsführer der Gesellschaft einlegt. Wird innerhalb von zwei (2) Wochen
kein Widerspruch gemäß des vorstehenden Satzes eingelegt, so werden die Stimmen der nicht an der Abstimmung teil-
nehmenden Gesellschafter als Enthaltungen gewertet. Schriftliche Beschlüsse sind von jedem Gesellschafter zu unter-
zeichnen und die Niederschrift ist jedem Gesellschafter unverzüglich zuzusenden. Beschlüsse, welche nicht in schriftlicher
Form gefasst werden, sind schriftlich zu bestätigen. Eine solche Bestätigung hat ausschließlich feststellende Bedeutung.

12.5 Von jedem Beschluss, der in Gesellschafterversammlungen gefasst wurde, ist unverzüglich eine Niederschrift

anzufertigen (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die Wirksamkeit), die das Datum und die Form des gefassten
Beschlusses, den Inhalt des Beschlusses und die abgegebenen Stimmen zu enthalten hat, es sei denn, die Gesellschafter-
beschlüsse wurden notariell beurkundet. Die Niederschrift muss jedem Gesellschafter unverzüglich in schriftlicher Form
zugesendet werden.

12.6 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschriften

des Abschnitts XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jede Bezugnahme auf die „Gesell-
schafterversammlung“ in der vorliegenden Satzung als Bezugnahme auf den Alleingesellschafter, je nach Zusammenhang
und soweit anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingesellschafter
ausgeübt.

Art. 13. Gesellschafterversammlung.
13.1 Gesellschafterversammlungen finden am Sitz der Gesellschaft oder an einem Ort und zu einer Zeit statt, welche

in der entsprechenden Einladung genauer bestimmt werden.

13.2  Die  Gesellschafterversammlung  wird  mittels  Einschreiben  (Zustellung  zu  eigenen  Händen,  Einschreiben  oder

Einschreiben mit Rückschein) an jeden Gesellschafter einberufen und beinhaltet den Ort, das Datum, die Uhrzeit und die
Tagesordnung,  wobei  bei  ordentlichen  Gesellschafterversammlungen  eine  Ankündigungsfrist  von  mindestens  vier  (4)
Wochen und bei außerordentlichen Gesellschafterversammlungen eine Ankündigungsfrist von mindestens zwei (2) Wo-
chen einzuhalten ist. Die Ankündigungsfrist beginnt am Tag nach dem Versand. Der Tag der Gesellschafterversammlung
wird bei der Berechnung der Ankündigungsfrist nicht berücksichtigt.

13.3 Falls alle Gesellschafter in einer Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten sind und auf Einladungs-

formalitäten verzichtet haben, kann die Versammlung auch ohne vorherige Ankündigung abgehalten werden.

13.4  Jeder  Gesellschafter  ist  dazu  berechtigt,  bei  der  Gesellschafterversammlung  von  einem  anderen  durch  eine

schriftliche Vollmacht dazu berechtigten Gesellschafter oder von einem Anwalt, Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer
unter der Berufsverschwiegenheitspflicht begleitet oder vertreten zu werden.

13.5 Eine Niederschrift hinsichtlich des Ablaufs der Versammlung ist (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die

Wirksamkeit) anzufertigen und hat den Ort und das Datum der Versammlung, die Teilnehmer, die Tagesordnungspunkte,
den Hauptinhalt der Verhandlungen und die Gesellschafterbeschlüsse zu beinhalten, es sei denn, die Verhandlungen der
Gesellschafterversammlung wurden notariell beurkundet. Die Niederschrift ist von allen bei der Gesellschafterversamm-
lung  anwesenden  oder  vertretenen  Gesellschaftern  zu  unterzeichnen  (als  Nachweis,  nicht  als  Voraussetzung  für  die
Wirksamkeit). Jedem Gesellschafter ist eine Kopie der Niederschrift zuzusenden.

Art. 14. Quorum und Abstimmung.
14.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.
14.2 Eine Gesellschafterversammlung ist nur dann beschlussfähig, wenn mindestens 50% des Gesellschaftskapitals ver-

treten sind. Vorbehaltlich anderer Regelungen dieser Satzung oder des Gesetzes von 1915, die ein höheres Mehrheits-
verhältnis vorsehen, bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von Gesellschaftern, die
mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals innehaben. Bei Beschlussunfähigkeit ist unverzüglich im Einklang mit Artikel
13.2 eine neue Gesellschafterversammlung mit derselben Tagesordnung einzuberufen. Diese Gesellschafterversammlung
ist dann unabhängig von dem vertretenen Gesellschaftskapital beschlussfähig, sofern darauf in der die Versammlung ein-
berufenden Ladung hingewiesen wurde und Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.

Art. 15. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.

120377

L

U X E M B O U R G

Art. 16. Änderung der Satzung.  Eine  Änderung  dieser  Satzung  erfordert  die  Zustimmung  (i)  einer  zahlenmäßigen

Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die gleichzeitig eine Qualifizierte Mehrheit darstellen. Eine Änderung dieser Satzung,
welche wesentliche oder nachteilige Auswirkungen auf die Rechte der Inhaber von Anteilen der Serie A1, Anteilen der
Serie A2, Anteilen der Serie A3, Anteilen der Serie A4 und Anteilen der Serie B hat, erfordert die Zustimmung aller
Inhaber solcher Anteile.

Art. 17. Beschlüsse, die eine spezifische Mehrheit erfordern.
17.1 Beschlüsse hinsichtlich der folgenden Angelegenheiten erfordern eine Qualifizierte Mehrheit und zudem die vor-

herige Zustimmung des Beirats:

17.1.1 Veräußerung des gesamten Gesellschaftsvermögens, eines beträchtlichen Anteils des Gesellschaftsvermögens

oder des gesamten oder eines beträchtlichen Anteils des Vermögens direkter oder indirekter Tochtergesellschaften der
Gesellschaft (einschließlich, unter anderem, der Übertragung von Rechten des geistigen Eigentums oder der Gesamtheit
der Rechte des geistigen Eigentums), sofern eine solche Veräußerung marktüblichen Bedingungen unterliegt:

17.1.2 Beschluss hinsichtlich der Liquidation der Gesellschaft;
17.1.3 Änderung dieser Satzung (Artikel 17 inbegriffen), einschließlich des Beschlusses hinsichtlich der Verschmelzung,

Ausgliederung und Umwandlung der Gesellschaft;

17.1.4 Verwendung des Jahresergebnisses; Zahlungen von Gewinnen in Kapitalreserven oder der Gewinnvortrag sol-

cher Gewinne auf neue Rechnung; Erhöhung oder Herabsetzung von Reserven (einschließlich, aber nicht beschränkt auf
das Agio und andere Kapitalreserven), sowie Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln;

17.1.5 Abschluss, Änderung oder Kündigung von Unternehmensverträgen (im Sinne der §§ 291 ff. des deutschen Ak-

tiengesetzes (AktG));

17.1.6 Abschluss, Beendigung oder Änderung von Unterbeteiligungen jeglicher Art einschließlich stiller Beteiligungen

an der Gesellschaft;

17.1.7 Genehmigung des Jahresplans für jedes folgende Jahr;
17.1.8 Übertragung von gewerblichen Schutzrechten oder von dokumentiertem Know-how durch die Gesellschaft an

Dritte.

17.2 Beschlüsse hinsichtlich der folgenden Angelegenheiten erfordern eine Qualifizierte Mehrheit und zudem die Zu-

stimmung aller Investoren:

17.2.1 Ausschluss von Bezugsrechten im Falle von Kapitalerhöhungen;
17.2.2 Erwerb eigener Anteile der Gesellschaft, einschließlich des Rückkaufs von Anteilen, mit Ausnahme der Erwerbe

gemäß Artikel 9.2 und Übertragungen gemäß Artikel 11.1 dieser Satzung.

17.3  Ist  das  Gesellschaftskapital  in  verschiedene  Anteilsklassen  unterteilt,  so  können  die  spezifischen  Rechte  und

Pflichten im Zusammenhang mit einer Anteilsklasse mit der einstimmigen und schriftlichen Zustimmung der Gesellschaf-
ter, die alle ausgegebenen Anteile dieser Anteilsklasse halten, verändert oder aufgehoben werden.

17.4 Änderungen im Beschlussfassungsprozess der Gesellschaft (einschließlich der Zuständigkeit der Gesellschafter-

versammlungen, der Sitzungen des Beirats und jeder notwendigen spezifischen Mehrheit zur Annahme einiger Beschlüsse)
zum einseitigen Nachteil eines Investors sind nicht ohne Zustimmung dieses Investors vorzunehmen. Zur Klarstellung
wird darauf hingewiesen, dass ein einseitiger Nachteil der Investoren bei einer Herabsetzung der Stimmanzahl oder bei
einer Änderung der Stimmrechte von Gesellschaftern oder Geschäftsführern besteht, die zur Annahme eines Beschlusses
erforderlich sind.

D. Rat der Geschäftsführer und Beirat

Art. 18. Befugnisse des Alleinigen Geschäftsführers; Zusammensetzung und Befugnisse des Rates der Geschäftsführer.
18.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Ge-

schäftsführer hat, bilden diese einen Rat der Geschäftsführer.

18.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „alleiniger Ge-

schäftsführer“ nicht ausdrücklich in dieser Satzung verwendet wird, ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Rat der
Geschäftsführer“ als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer“ auszulegen.

18.3 Der Rat der Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, im Namen der Gesellschaft zu handeln

und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.

Art. 19. Ernennung, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
19.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung ernannt, welche ihre Bezüge und

ihre Amtszeit festlegt.

19.2 Die Geschäftsführer können durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung jederzeit und ohne Grund

ernannt oder abberufen werden.

19.3 Die Gesellschafterversammlung kann die Ernennung von Geschäftsführern zwei (2) unterschiedlicher Kategorien

beschließen, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Eine solche Klassifizierung

120378

L

U X E M B O U R G

der Geschäftsführer muss ordnungsgemäß in der Niederschrift des betreffenden Gesellschafterbeschlusses festgehalten
und die Geschäftsführer der Kategorie, der sie angehören, zugeordnet werden.

Art. 20. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
20.1  Scheidet  ein  Geschäftsführer  durch  Tod,  Geschäftsunfähigkeit,  Insolvenz,  Rücktritt  oder  aus  einem  anderem

Grund aus seinem Amt aus, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen
die ursprüngliche Amtszeit des ersetzten Geschäftsführers nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesell-
schafterversammlung ausgefüllt werden, welche im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die
endgültige Ernennung entscheidet.

20.2  Für  den Fall,  dass  der alleinige Geschäftsführer  aus seinem Amt  ausscheidet, muss die  frei  gewordene  Stelle

unverzüglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.

Art. 21. Einladung zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
21.1 Der Rat der Geschäftsführer versammelt sich auf Einberufung durch einen Geschäftsführer. Die Sitzungen des

Rates der Geschäftsführer finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.

21.2  Die  Geschäftsführer  werden  mindestens  vierundzwanzig  (24)  Stunden  vor  dem  für  die  Sitzung  anberaumten

Zeitpunkt zu jeder Sitzung des Rates der Geschäftsführer schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe
der Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Geschäftsführer
per Post, Fax, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abgegeben haben, wobei
eine Kopie eines solchen Dokuments ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung zu Sitzungen des Rates der Ge-
schäftsführer ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss des Rates der Geschäftsführer
bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.

21.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle

Einladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Rates
der Geschäftsführer diesen zustimmen und diese unterzeichnen.

Art. 22. Geschäftsführung.
22.1 Der Rat der Geschäftsführer kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Rat der Ge-

schäftsführer kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise selbst ein Geschäftsführer sein muss
und der für die Protokollführung der Sitzungen des Rates der Geschäftsführer verantwortlich ist.

22.2 Sitzungen des Rates der Geschäftsführer werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Rates der Ge-

schäftsführer geleitet. In dessen Abwesenheit kann der Rat der Geschäftsführer einen anderen Geschäftsführer durch
einen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Mitglieder als Vorsitzenden pro tempore ernennen.

22.3 Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer teilnehmen, indem er einen anderen

Geschäftsführer schriftlich oder durch Faxschreiben, per E-Mail oder durch ein anderes vergleichbares Kommunikati-
onsmittel bevollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Geschäftsführer
kann einen oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.

22.4 Eine Sitzung des Rates der Geschäftsführer kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein

anderes Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu
hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel
ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung gilt als am Sitz der Ge-
sellschaft abgehalten.

22.5 Der Rat der Geschäftsführer kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest eine Mehrheit der

Geschäftsführer in einer Sitzung anwesend oder vertreten ist.

22.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Rates der Geschäftsführer

teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden,
hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme. Sofern die Gesellschafterversammlung allerdings un-
terschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäfts-
führer der Kategorie B), werden Beschlüsse des Rates der Geschäftsführer nur dann wirksam gefasst, wenn sie von der
Mehrheit der Geschäftsführer einschließlich mindestens eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsfüh-
rers der Kategorie B (oder deren Vertreter) gefasst werden.

22.7 Der Rat der Geschäftsführer kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung,

per Faxschreiben, per E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Jeder Geschäftsführer kann
seine Zustimmung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreff-
enden Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.

22.8 Die Geschäftsführer benötigen die Zustimmung des Beirats für die untenstehenden Rechtsgeschäfte und Maß-

nahmen der Gesellschaft (eine Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn solche Rechtsgeschäfte und Maßnahmen präzise
definiert und im Voraus von einem bewilligten Haushaltsplan mit der Zustimmung der Gesellschafterversammlung ge-
nehmigt wurden):

22.8.1 Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder ähnlichen Verpflichtungen, die einen Betrag von fünfhunderttau-

send Euro (EUR 500.000,00) überschreiten;

120379

L

U X E M B O U R G

22.8.2 Termingeschäfte über Devisen, Sicherheiten und börsengehandelte Waren und Rechte, sowie weitere Trans-

aktionen mit derivaten Finanzinstrumenten;

22.8.3 Gewährung, Einführung und Änderung von Versorgungsverpflichtungen jeglicher Art;
22.8.4 Abschluss, Änderung oder Kündigung von Unternehmenstarifverträgen, Betriebsvereinbarungen (von erhebli-

cher Bedeutung) und allgemeiner Richtlinien hinsichtlich der betrieblichen Altersvorsorge der Gesellschaft;

22.8.5 Einleitung und Beendigung von Rechtsstreitigkeiten, insbesondere Schiedsgerichtsverfahren mit einem Streit-

wert von über fünfhunderttausend Euro (EUR 500.000,00) im Einzelfall;

22.8.6 Weitergabe von gewerblichen Schutzrechten oder Know-how von der Gesellschaft an Dritte;
22.8.7 Abschluss, Beendigung oder Änderung von Unterbeteiligungen jeglicher Art einschließlich stiller Beteiligungen

an der Gesellschaft;

22.8.8 Transaktionen der Gesellschaft und ihrer Investoren mit verbundenen juristischen und natürlichen Personen,

wie in Gesellschaftervereinbarungen zwischen den Gesellschaftern dargelegt; und

22.8.9 Abschluss von, Änderungen an und Kündigung von Unternehmensverträgen (im Sinne der §§ 291 ff. des deut-

schen Aktiengesetzes (AktG)).

Beschlüsse bezüglich der Einführung eines Mitarbeiter-Beteiligungsmodells bedürfen der Zustimmung des Beirats.
22.9 Ist die Zustimmung zum Erwerb, zum Verkauf oder zur Belastung von Objekten wie oben beschrieben erforder-

lich, so ist die Zustimmung ebenfalls für die damit verbundenen vertraglichen Verpflichtungen erforderlich. Die Gesell-
schafterversammlung kann durch einen Beschluss weitere Transaktionen und Maßnahmen bestimmen, die die Zustimmung
des Beirats erfordern. Der Beirat kann seine Zustimmung für bestimmte Gruppen und Arten von Transaktionen und
Maßnahmen auch im Voraus erteilen.

22.10 Die Gesellschafter können durch einen Gesellschafterbeschluss oder eine Gesellschaftervereinbarung eine Ge-

schäftsordnung für die Geschäftsführer beschließen.

22.11 Die Geschäftsführung hat sicherzustellen, dass die Bestimmungen dieses Artikels 22, soweit gesetzlich möglich,

auf die gleiche Weise auf sämtliche verbundenen Gesellschaften angewendet werden, in welchen die Gesellschaft direkt
oder indirekt gegenwärtig oder künftig eine Mehrheitsbeteiligung hält.

Art. 23. Protokoll von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer Protokoll der Entscheidungen des Alleinigen Ge-

schäftsführers.

23.1 Das Protokoll einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer wird vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer,

falls vorhanden, oder, im Falle seiner Abwesenheit, vom Vorsitzenden pro tempore und dem Schriftführer (falls vorhan-
den), oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unterschied-
liche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der
Kategorie B), werden Protokolle von einem (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einem (1) Geschäftsführer der
Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsver-
fahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer, falls
vorhanden, oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden solche Kopien oder Auszüge von einem (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einem (1)
Geschäftsführer der Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet.

23.2 Die Entscheidungen des alleinigen Geschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom alleinigen

Geschäftsführer unterzeichnet wird. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet.

Art. 24. Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Um-

ständen  (i)  durch  die  Unterschrift  des  alleinigen  Geschäftsführers,  oder,  für  den  Fall,  dass  die  Gesellschaft  mehrere
Geschäftsführer hat, durch die gemeinsamen Unterschriften zwei (2) beliebiger Geschäftsführer wirksam verpflichtet;
sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäfts-
führer  der  Kategorie  A  und  Geschäftsführer  der  Kategorie  B),  wird  die  Gesellschaft  nur  durch  die  gemeinsamen
Unterschriften mindestens eines (1) Geschäftsführers der Kategorie A und eines (1) Geschäftsführers der Kategorie B
(oder deren Vertreter), oder (ii) durch die gemeinsamen Unterschriften oder die alleinige Unterschrift jedweder Person
(en), der/denen eine Unterschriftsbefugnis durch den Rat der Geschäftsführer übertragen worden ist, wirksam verpflich-
tet.

Art. 25. Beirat.
25.1 Die Gesellschaft hat einen Beirat (der „Beirat“). Dieser besteht aus sechs (6) stimmberechtigten Mitgliedern und

zusätzlichen nicht-stimmberechtigten Mitgliedern (die „Beobachter“). Die Gesellschafterversammlung kann durch einen
einstimmigen Gesellschafterbeschluss die Anzahl der Mitglieder des Beirats erhöhen oder herabsetzen.

25.2 Die Gesellschafterversammlung kann die Geschäftsordnung für den Beirat nur durch einen einstimmigen Gesell-

schafterbeschluss oder eine Gesellschaftervereinbarung genehmigen oder verändern.

120380

L

U X E M B O U R G

25.3 Jeder der Investoren ist jederzeit dazu berechtigt, einen nichtstimmberechtigten Beobachter des Beirats zu er-

nennen,  der  zur  Teilnahme  an  Sitzungen  des  Beirats  berechtigt  ist  und  zur  gleichen  Zeit  wie  die  stimmberechtigten
Mitglieder alle vorbereitenden Dokumente, Einladungen zu Sitzungen und Protokolle des Beirats erhält.

25.4 Die stimmberechtigten Mitglieder des Beirats werden von dem entsprechenden ernennenden Gesellschafter jedes

Mitglieds durch schriftliche Mitteilung an die Gesellschaft wie folgt ernannt, abberufen oder ersetzt:

25.4.1 zwei (2) stimmberechtigte Mitglieder des Beirats werden von dem Gesellschafter AIH nach eigenem Ermessen

ernannt;

25.4.2 drei (3) stimmberechtigte Mitglieder des Beirats werden von dem Gesellschafter LIH nach eigenem Ermessen

ernannt;

25.4.3 ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats wird von dem Gesellschafter Phenomen nach eigenem Ermessen

ernannt.

Jedes stimmberechtigte Mitglied des Beirats hat eine (1) Stimme.
25.5 Der Beirat ist für die Erteilung von Zustimmungen zu Transkationen und Maßnahmen der Geschäftsführer zu-

ständig, welche die Gesellschafterversammlung vorbehaltlich der Zustimmung des Beirats (i) in dieser Satzung, (ii) in der
Geschäftsordnung für die Geschäftsführer, (iii) durch einen Gesellschafterbeschluss oder (iv) in einer Gesellschafterver-
einbarung, vorgenommen hat.

25.6 Die Vergütung der Mitglieder des Beirats wird, sofern vorgesehen, von den Gesellschaftern der Gesellschaft durch

einstimmigen Gesellschafterbeschluss festgelegt.

25.7 Neben den Zustimmungserfordernissen gemäß Artikel 22.8 und Artikel 22.9 hat der Beirat eine beratende Funk-

tion und wird nicht in die Geschäftsführung der Gesellschaft eingreifen.

25.8 Der Beirat ist kein Aufsichtsrat im Sinne des Artikels 60bis-11 ff. des Gesetzes von 1915.

E. Aufsicht und Prüfung der Gesellschaft

Art. 26. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
26.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der

Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer (commissaire(s)) beaufsichtigt. Die Gesellschafterversammlung
ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.

26.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
26.3 Die Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Recht der permanenten Überprüfung und Kontrolle aller Ge-

schäfte der Gesellschaft.

26.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember

2002  betreffend  das  Handelsregister  und  die  Buchhaltung  und  den  Jahresabschluss  von  Unternehmen,  in  der  jeweils
gültigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d’entreprises agréé(s)) ernennen, entfällt
die Funktion des Rechnungsprüfers.

26.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die

Gesellschafterversammlung abberufen werden.

F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinnverwendung - Abschlagsdividenden

Art. 27. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am

einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

Art. 28. Jahresabschluss und Gewinne.
28.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Rat der Geschäftsführer erstellt im

Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und
Verlustrechnung.

28.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage

der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.

28.3  Durch  einen  Gesellschafter  erbrachte  Einlagen  in  Rücklagen  können  mit  Zustimmung  dieses  Gesellschafters

ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.

28.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage der Gesellschaft verhältnis-

mäßig herabgesetzt werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.

28.5 Auf Vorschlag des Rates der Geschäftsführer bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den Be-

stimmungen des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung, wie der verbleibende jährliche Nettogewinn der Gesellschaft
verwendet werden soll.

28.6 Vorbehaltlich des Artikels 8 erfolgen Ausschüttungen an die Gesellschafter proportional zur Anzahl der von ihnen

an der Gesellschaft gehaltenen Anteile.

120381

L

U X E M B O U R G

Art. 29. Abschlagsdividenden Agio und Andere Kapitalreserven.
29.1 Der Rat der Geschäftsführer kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche

vom Rat der Geschäftsführer vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur
Verfügung stehen. Der ausschüttbare Betrag wird gegebenenfalls im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 8 verteilt
und darf nicht die Summe der seit dem Ende des vergangenen Geschäftsjahres angefallenen Gewinne, gegebenenfalls
erhöht  durch  vorgetragene  Gewinne  und  ausschüttbare  Rücklagen,  beziehungsweise  vermindert  durch  vorgetragene
Verluste und Summen, die einer Rücklage zugeführt werden, welche nach dem Gesetz von 1915 oder dieser Satzung nicht
ausgeschüttet werden darf, übersteigen.

29.2 Das Agio, andere Kapitalreserven oder andere ausschüttbare Rücklagen können im Einklang mit den Bestimmun-

gen des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

G. Liquidation

Art. 30. Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Liqui-

dation durch einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden,
die über die Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit
nichts anderes bestimmt wird, haben die Liquidatoren die weitestgehenden Befugnisse für die Verwertung der Vermö-
genswerte und die Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

H. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht

Art. 31. Anwendbares Recht.
31.1 Sämtliche in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten unterliegen den Bestimmungen des Gesetzes von

1915 und jeder Gesellschaftervereinbarung, die die Gesellschafter in der Zwischenzeit mit der Gesellschaft eingehen und
durch die bestimmte Bestimmungen dieser Satzung ergänzt werden könnten. Sollte ein Artikel dieser Satzung mit den
Bestimmungen einer Gesellschaftervereinbarung in Widerspruch stehen, so ist die Gesellschaftervereinbarung zwischen
den Parteien, soweit nach luxemburgischem Recht zulässig, maßgebend.

31.2 Diese Satzung wurde auf Englisch verfasst, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; im Falle von Abweichungen

zwischen der englischen und der deutschen Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.“

6. Verschiedenes.
Nach ordnungsgemäßer Prüfung jedes Tagesordnungspunkts fasst die Gesellschafterversammlung einstimmig die fol-

genden Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, eine weitere (1) Klasse von Anteilen zu schaffen, welche als Anteile der

Klasse B bezeichnet werden (die „Anteile der Klasse B“), wodurch nunmehr insgesamt sechs (6) Anteilsklassen bestehen.

<i>Zweiter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung nimmt Phenomen, vorbenannt, als neuen Gesellschafter der Gesellschaft an.

<i>Dritter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, das Gesellschaftskapital der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von

fünfundzwanzigtausend Euro (EUR 25.000) um einen Betrag von viertausendneunhundertzwei Euro (EUR 4.902) auf einen
Betrag von neunundzwanzigtausendneunhundertzwei Euro (EUR 29.902) durch die Ausgabe von viertausendneunhun-
dertzwei (4.902) Anteilen der Serie B mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1), zu erhöhen.

<i>Zeichnung

Viertausendneunhundertzwei (4.902) Anteile der Serie B wurden ordnungsgemäß von Phenomen, vorbenannt, hier

wie oben dargelegt vertreten, zu einem Preis von viertausendneunhundertzwei Euro (EUR 4.902) gezeichnet.

<i>Zahlung

Die von Phenomen, vorbenannt, gezeichneten viertausendneunhundertzwei (4.902) Anteile der Serie B wurden voll-

ständig eingezahlt durch eine Bareinlage in Höhe von viertausendneunhundertzwei Euro (EUR 4.902).

Der Nachweis über die Existenz und den Wert der oben bezeichneten Einlage wurde dem unterzeichnenden Notar

durch die Vorlage eines Sperrzertifikats erbracht.

Die Einlage in Höhe von viertausendneunhundertzwei Euro (EUR 4.902) wird vollständig dem Gesellschaftskapital

zugeführt.

<i>Vierter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, Artikel fünf Punkt eins (5.1) der Satzung der Gesellschaft zu ändern, welcher

nunmehr wie folgt lautet:

120382

L

U X E M B O U R G

„ 5.1. Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt neunundzwanzigtausendneunhundertzwei Euro (EUR 29.902),

bestehend  aus  (i)  zwölftausendfünfhundert  (12.500)  Stammanteilen  (die  „Stammanteile”),  (ii)  dreitausendzweihunder-
tachtundsechzig (3.268) Anteilen der Serie A1 (die „Anteile der Serie A1“), (iii) achttausendeinhundertsiebzig (8.170)
Anteilen der Serie A2 (die „Anteile der Serie A2“), (iv) vierhundertacht (408) Anteilen der Serie A3 (die „Anteile der
Serie A3“), (v) sechshundertvierundfünfzig (654) Anteilen der Serie A4 (die „Anteile der Serie A4“) und (vi) viertausend-
neunhundertzwei (4.902) Anteilen der Serie B (die „Anteile der Serie B“), mit einem Nominalwert von je einem Euro
(EUR 1).“

<i>Fünfter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, unter anderem infolge des Vorstehenden, einstimmig die gänzliche Neu-

fassung der Satzung der Gesellschaft, welche nunmehr wie in der Tagesordnung der vorliegenden Urkunde dargestellt
lautet.

Da die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung geschlossen.

<i>Kosten und Auslagen

Die Kosten, Auslagen, Honorare und Gebühren jeglicher Art, die von der Gesellschaft zu tragen sind, werden auf

ungefähr tausendsechshundert Euro (EUR 1.600,-) geschätzt.

Hierüber wurde diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen.
Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache beherrscht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende

Urkunde auf Verlangen der erschienenen Parteien auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung;
auf Verlangen besagter erschienener Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen
Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.

Die vorstehende Urkunde ist der Bevollmächtigten der erschienenen Parteien, welche dem Notar mit Namen, Vorn-

amen und Wohnsitz bekannt ist, verlesen und vom Notar gemeinsam mit dieser Bevollmächtigten unterzeichnet worden.

Signé: A. van der Wielen, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 juin 2014. LAC/2014/28997. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 11 juillet 2014.

Référence de publication: 2014105674/1240.
(140126099) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2014.

Antias Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 95.039.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014100744/10.
(140120850) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

Dzeta Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 141.125.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 juillet 2014.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Maître Carlo WERSANDT
<i>Notaire

Référence de publication: 2014102983/14.
(140121410) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2014.

120383

L

U X E M B O U R G

Reinbro Investments SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 86.780.

L'an deux mille quatorze, le deux juillet.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est tenue

une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous la déno-

mination de "REINBRO INVESTMENTS SA", inscrite au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B 86780, ayant son siège
social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, constituée par acte de Maître André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, alors
notaire de résidence à Luxembourg, en date du 5 avril 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C
numéro 987 du 28 juin 2002. Les statuts de la société n'ont pas été modifiés depuis.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Michaël ZIANVENI, juriste, domicilié professionnellement au

18, rue de l'Eau, L- 1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Marilyn KRECKÉ, employée privée, domiciliée profession-

nellement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Gianpiero SADDI, employé privé, domicilié professionnellement au 74,

avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les deux cents (200) actions

d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de deux cent mille
euros (EUR 200.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement consti-
tuée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduits, tous les
actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

II.- Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Dissolution de la société et mise en liquidation.
2. Nomination d'un ou plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
3. Divers.
L'Assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale nomme aux fonctions de liquidateur, pour la durée de la liquidation, la société LISOLUX S.à r.l.,

inscrite au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B 117503, ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg,
qui aura les pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquidation, y compris ceux de réaliser les opérations prévues à
l'article 145 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'Assemblée s'est terminée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: M. Zianveni, M. Krecké, G. Saddi et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 10 juillet 2014. LAC/2014/32400. Reçu douze euros (12.- €).

<i>Le Receveur (signée): Irène Thill.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 juillet 2014.

Référence de publication: 2014102528/51.
(140123413) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2014.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

120384


Document Outline

Abano Sàrl

Aberdeen Global Property Multi Manager S.A.

Aerium Erlangen S.à.r.l.

Aerium Erlangen S.à.r.l.

A-F-F Consulting S.à r.l.

Affret'Partners Sàrl

Aida Wedo 3

Aircraft Holding Solutions Lux S.à r.l.

Alaskan Luxembourg S.C.A.

Aldorf &amp; Norbereit Invest S.A.

Alifa S.A.

Alison Holdco S.à r.l.

Allfin Holding Luxembourg Sàrl

AltaLux Italy S.à r.l.

AltaLux Spain S.à r.l.

Altho S.à r.l.

Altimum S.à r.l.

Altro Teatro S.A.

AMMF Investment

Ampala S.àr.l.

Ampala S.àr.l.

AMS Luxembourg S.à r.l.

Antala S.à r.l.

Antias Finance S.A.

APERAM Stainless Services &amp; Solutions Luxembourg S.A.

Apollo 10 S.à r.l.

Apollo 11 S.à r.l.

Apollo Warehouse S.à r.l.

Apolux S.A.

Applex S.A.

ARAMIS Luxembourg S.à r.l.

AR Intellectual Property S.à r.l.

Arithmex

ATEEL - Allied Technology Experts Enterprise of Luxembourg S.à r.l.

Axys Consultants Luxembourg S.A.

Azure Global Microfinance Fund

BIOCARDEL Europe S.A.

Bluehouse Capital Advisors S.à r.l.

Caletaster S.A.

Centralis S.A.

Corporate XII

Dzeta Group S.à r.l.

Emerging Markets Taxi Holding S.à r.l.

Impelect S.à r.l.

Iona Bruxelles S.à r.l.

M3 Lux Catering S.à.r.l.

MCP Private Capital Fund I

Mirae Asset Global Discovery Fund

Mitco Real Estate C S.à r.l.

MN S.A.

Montrium S.A.

Munsterfred Property S.à r.l.

Olays S.A.

Peakside Blueprint S.à r.l.

Petroleum Services Exploitation S.A.

Pétrusse Participations S.A.

PLJ Chelsea

Prax Capital China Growth Fund III, S.C.A., SICAR

Reinbro Investments SA

Wasaby S.A.

Weatherford European Holdings (Luxembourg) S.à r.l.

Yopla International S.A.