logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2505

17 septembre 2014

SOMMAIRE

Alce Investment I S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

120206

Alcove Europe Two S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

120206

Apollo 11 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120206

Aramis International 1 S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

120206

Ben Zion S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120197

Bepaumat Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120194

Berwand S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120194

Berwand S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120195

BOP Properties S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120195

Bords de Seine 1 Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

120196

Braga Holding  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120197

Bucobi S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120196

Büko Immobilien S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120198

Business Pollination S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

120198

Callassou International S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

120201

Camping-Concept Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . .

120202

Campria Capital S.A. S.P.F.  . . . . . . . . . . . . .

120202

Carcenter S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120194

Casada Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120195

Casinvest Iena S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120197

Castello Borghese S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

120201

Centralis Immobilière S.à r.l. . . . . . . . . . . . .

120202

CEP D'or S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120204

CEP III Investments S.C.A. . . . . . . . . . . . . . .

120196

CEREP GAB S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120239

Chemtech  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120199

Chemtrade Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . .

120203

CS Investment Funds 2  . . . . . . . . . . . . . . . . .

120207

CVC Investments Vista II S.C.A. . . . . . . . . .

120195

Diapason Gestion S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120239

Digital Services XXXII (GP) S.à r.l . . . . . . .

120210

Emo - Produits de Viande - Differdange  . .

120240

Epajona S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120195

Floral S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120198

G.A.T.S. Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120205

Gerona Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

120204

Getinge Holding Luxembourg S.à r.l.  . . . .

120204

Interminerals S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120200

JF Construction S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120233

Larry Berlin I S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120196

Larry II Potsdam S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

120197

Longeville S.A. SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120200

Lux 39 Starlight GBP S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

120200

Luxury Fashion Luxembourg S.A.  . . . . . . .

120199

Madera S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120205

Maine Consulting S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120205

MDC Holdco S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120201

Milort S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120203

Morgan Stanley Equity Derivative Services

(Luxembourg) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120205

Multipharma S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120203

PLJ Chelsea  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120235

Queensgate Investments II s.à R.L.  . . . . . .

120221

SCPack Holdings Management S.à r.l &

Partners S.C.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120198

SJ Properties Aubervilliers DebtCo Lux

S.C.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120199

Stibbe Luxembourg Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . .

120202

Store Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120201

Sud Petrol S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120194

Tiareno Trade S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120194

120193

L

U X E M B O U R G

Bepaumat Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof, 4, rue d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 178.486.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014100815/10.
(140121284) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

Berwand S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8077 Bertrange, 91, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 56.794.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014100816/10.
(140120701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

Tiareno Trade S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 176.105.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Tiareno Trade S.A.
Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2014101670/11.
(140120444) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

Sud Petrol S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.

Siège social: L-4450 Belvaux, 65, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 166.931.

L’adresse de l’administrateur de la société est la suivante:
226, route d’Arlon, L-8010 STRASSEN

Belvaux, le 14 juillet 2014.

La société

Référence de publication: 2014101660/11.
(140121292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

Carcenter S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8430 Strassen, 34-36, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 92.460.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14.07.2014.

Paul DECKER
<i>Le Notaire

Référence de publication: 2014100883/12.
(140121213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

120194

L

U X E M B O U R G

Berwand S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8077 Bertrange, 91, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 56.794.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014100817/10.
(140120702) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

BOP Properties S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 15, rue de Flaxweiler.

R.C.S. Luxembourg B 80.248.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014100828/10.
(140120799) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

CVC Investments Vista II S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 178.143.

Les comptes annuels pour la période du 18 juin 2013 (date de constitution) au 31 décembre 2013 ont été déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juin 2014.

Référence de publication: 2014100932/11.
(140120638) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

Epajona S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 158.010.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Epajona S.àr.l.
Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2014100974/11.
(140120287) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

Casada Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 3, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 30.638.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 juillet 2014.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

Référence de publication: 2014100886/12.
(140121303) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

120195

L

U X E M B O U R G

Bords de Seine 1 Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 154.033.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014100799/9.
(140121583) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

Bucobi S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9147 Erpeldange, 47, rue Laduno.

R.C.S. Luxembourg B 130.355.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Erpeldange, le 11.07.2014.

Signature.

Référence de publication: 2014100834/10.
(140120706) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

CEP III Investments S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 123.769.

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 27 juin 2014 que le mandat du réviseur

d'entreprise Ernst &amp; Young est renouvelé pour l'exercice de la Société s'achevant le 31 décembre 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juillet 2014.

CEP III Investments S.C.A.
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014100895/13.
(140120451) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

Larry Berlin I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1253 Luxembourg, 2A, rue Nicolas Bové.

R.C.S. Luxembourg B 159.506.

Changement suivant le contrat de cession de parts du 13 juin 2014:
- Ancienne situation associées:
Larry Residential Equities (Berlin) S.à r.l.: 26 parts sociales
Larry I Targetco (Berlin) GmbH: 474 parts sociales
- Nouvelle situation associées:

Parts

sociales

AWL Properties I S.C.S., une société en commandite simple (S.C.S.), ayant son siège social à 23, avenue
Monterey, L-2163 Luxembourg, enregistrée auprès du R.C.S. Luxembourg sous le numéro B187497 . . . . .

26

Larry I Targetco (Berlin) GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

474

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Luxembourg, le 16 juillet 2014.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour Larry Berlin I S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2014102294/22.
(140123155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2014.

120196

L

U X E M B O U R G

Braga Holding, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 174.856.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014100800/9.
(140121567) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

Casinvest Iena S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 145.288.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014100848/9.
(140121159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

Ben Zion S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 90.449.

Le Bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juillet 2014.

<i>Pour Ben Zion S.à r.l.
Stéphane Hépineuze
<i>Gérant

Référence de publication: 2014100790/13.
(140120363) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

Larry II Potsdam S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1253 Luxembourg, 2A, rue Nicolas Bové.

R.C.S. Luxembourg B 164.348.

Changement suivant le contrat de cession de parts du 13 juin 2014:
- Ancienne situation associées:
Larry Residential Equities (Berlin) S.à r.l.: 26 parts sociales
Larry II Targetco (Berlin) GmbH: 474 parts sociales
- Nouvelle situation associées:

Parts

sociales

AWL Properties I S.C.S., une société en commandite simple (S.C.S.),
ayant son siège social à 23, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,
enregistrée auprès du R.C.S. Luxembourg sous le numéro B187497 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26

Larry II Targetco (Berlin) GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

474

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Luxembourg, le 16 juillet 2014.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour Larry II Potsdam S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2014102306/23.
(140123378) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2014.

120197

L

U X E M B O U R G

Business Pollination S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4751 Pétange, 165A, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 122.696.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014100835/10.
(140120985) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

Büko Immobilien S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.

R.C.S. Luxembourg B 104.346.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinter-

legt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014100837/10.
(140121023) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

SCPack Holdings Management S.à r.l &amp; Partners S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 167.051.

Statuts coordonnés, suite à un constat d’augmentation de capital reçu par Maître Francis KESSELER, notaire de rési-

dence à Esch/Alzette, en date du 8 janvier 2014 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 10 février 2014.

Référence de publication: 2014102584/11.
(140123633) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2014.

Floral S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 139.536.

<i>Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale tenue le 12 juin 2014 à 11h00

<i>Décisions

1. Renouveler les mandats des administrateurs:
- Emmanuel LEBEAU, ayant son adresse au 4 A rue Henri Schnadt, L - 2530 Luxembourg,
- Olivier GRANBOULAN, ayant son adresse au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg,
- Jean-Michel MARQ, ayant son adresse au 5, rue du Parc, L-8301 Strassen,
Les mandats des Administrateurs arriveront à échéance à l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes annuels

de l'exercice clos au 31 décembre 2014.

2.  Renouveler  le  mandat  du  Commissaire  aux  Comptes  FIDUCIAIRE  HRT,  ayant  son  siège  social  1A,  Romescht,

Résidence Les Cerisiers n°2, L-7364 Bofferdange, dûment enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Lu-
xembourg sous le numéro B125213.

Le mandat du Commissaire aux Comptes arrivera à échéance à l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes

annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2014.

Suite à cet exposé, aucune remarque n'est formulée, l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Signatures
<i>Le Président / Le Secrétaire

Référence de publication: 2014102142/23.
(140122778) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2014.

120198

L

U X E M B O U R G

Chemtech, Société Anonyme.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.

R.C.S. Luxembourg B 56.065.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014100907/9.
(140120994) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

Luxury Fashion Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 174.667.

<i>Extrait des résolutions circulaires du conseil d'administration de la société

Le conseil d'administration de la Société a pris connaissance de la démission de Alexis Babeau de ses fonctions d'ad-

ministrateur de catégorie B de la Société avec effet au 31 mai 2014.

Le conseil d'administration de la Société a décidé de coopter Jean-Marc Duplaix, dont l'adresse professionnelle se situe

10, avenue Hoche, 75381 Paris Cedex 08, France, comme administrateur de catégorie B de la Société avec effet au 10
juin 2014 jusqu'à la date de la prochaine assemblée générale des actionnaires de la Société qui décidera de sa nomination
définitive comme membre du conseil d'administration de la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LUXURY FASHION LUXEMBOURG S.A.
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014105085/17.
(140125764) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2014.

SJ Properties Aubervilliers DebtCo Lux S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Capital social: EUR 36.000,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 124.781.

En date du 02 juillet 2014 les associés de la Société ont pris les décisions suivantes:
1. L'acceptation de la démission de M. Gudjon ASMUNDSSON de ses fonctions de Commissaire membre du Conseil

de Surveillance de la Société avec effet au 02 juin 2014;

2. L'acceptation de la démission de M. Oskar Gardarsson de ses fonctions de Commissaire membre du Conseil de

Surveillance de la Société avec effet au 02 juin 2014;

3. L'acceptation de la démission de M. Johann Friorik Haraldsson de ses fonctions de Commissaire membre du Conseil

de Surveillance de la Société avec effet au 02 juin 2014;

4. Election des nouveaux Commissaires membres du Conseil de Surveillance, à compter du 02 juin 2014 pour une

durée indéterminée:

- M. Snorri Arnar Vidarsson, né le 18 août 1977, à Reykjavik, en Islande, ayant pour adresse professionnelle Sóltún 26,

105 Reykjavik, Islande;

- Mr. Kristjàn Oskarsson, né le 24 septembre 1951, à Reykjavik, en Islande, ayant pour adresse professionnelle Sóltún

26, 105 Reykjavik, Islande;

- M. Ingolfur Hauksson, né le 04 juin 1960, à Bolungarvik, en Islande, ayant pour adresse professionnelle Sóltún 26, 105

Reykjavik, Islande,

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SJ PROPERTIES AUBERVILLIERS DEBTCO LUX S.C.A.
TMF Luxembourg S.A.
Signatures
<i>Agent domiciliataire

Référence de publication: 2014102604/28.
(140122986) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2014.

120199

L

U X E M B O U R G

Longeville S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 170.105.

Par décision du Conseil d'administration du 14 juillet 2014:
KOFFOUR S.A., société anonyme, R.C.S. Luxembourg B-86086, 42 rue de la Vallée, L -2661 Luxembourg, a désigné

comme représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour son compte au conseil d'admi-
nistration de la société LONGEVILLE S.A. SPF, Monsieur Raphaël EBER, 42 rue de la Vallée, L - 2661 Luxembourg, en
remplacement de Monsieur Guy Baumann, démissionnaire.

Luxembourg, le 17 juillet 2014.

<i>Pour: LONGEVILLE S.A. SPF
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme

Référence de publication: 2014105101/17.
(140125033) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2014.

Interminerals S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 38.440.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait

Par jugement rendu en date du 3 juillet 2014, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Sixième Chambre,

siégeant en matière commerciale, après avoir entendu Madame le Juge Commissaire en son rapport oral, le liquidateur
et le Ministère Public en ses conclusions, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société
suivante:

La société INTERMINERALS SA, ayant eu son siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la foire, dénoncé en

date du 19 avril 1995 et ayant été immatriculée au registre de commerce sous le numéro B38440

Ce même jugement a mis les frais à la charge du trésor.

Pour extrait conforme
Maître Philippe GODEBERT
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2014103259/18.
(140122176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2014.

Lux 39 Starlight GBP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 13.000,00.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.

R.C.S. Luxembourg B 188.075.

Il résulte d'un contrat de transfert de parts sociales prenant effet en date du 17 juillet 2014 que la société Starwood

Capital Operations, LLC dont le siège social se situe Corporation trust Centre, 1209 Orange Street, City of Wilmington,
County of New Castle, State of Delaware, USA, a cédé toutes les parts sociales qu'elle détenait dans la Société, soit:

- 500 (cinq cents) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de GBP 26 (vingt six GBP) chacune à la société

SOF-10 Lux Master Co S.à r.l. dont le siège social se situe 5 rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 186 115.

Les détenteurs de parts sociales sont désormais les suivants:
- SOF-10 Lux master Co S.à r.l.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Thierry Drinka
<i>Gérant

Référence de publication: 2014105082/19.
(140125388) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2014.

120200

L

U X E M B O U R G

Callassou International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 81.061.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014100877/10.
(140120035) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

Castello Borghese S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 86, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 68.999.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014100887/10.
(140120986) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

MDC Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: ZAR 1.006.370,00.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 134.988.

Il résulte des actes de la Société que le siège social de l'associé RTH Euro Investments II Limited est désormais au No.

2 The Form, Grenville Street, St Helier, Jersey JE1 4HH.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

MDC HOLDCO S.à.r.l.
Société à Responsabilité Limitée
Signature

Référence de publication: 2014102394/14.
(140123468) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2014.

Store Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon Ier.

R.C.S. Luxembourg B 94.789.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 3 juin 2014

I. L'assemblée générale constate que le mandat d'administrateur délégué de Monsieur Robert FRANK, né le 15 mars

1964 à Esch-sur-Alzette, demeurant 1, rue de Luxembourg à L-5760 Hassel, arrive à échéance. L'assemblée générale
décide à l'unanimité de renouveler son mandat d'administrateur délégué pour une durée d'un an. Son mandat prendra
donc fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes clos au 31.12.2014 qui se tiendra en 2015.

II. L'assemblée générale des actionnaires constate que le mandat de commissaire aux comptes de la société COM-

MISSAIRE AUX COMPTES S.A. établie au 44, rue Pasteur à L-4276 Esch-sur-Alzette, immatriculée au RCS de Luxembourg
sous le numéro B131.410, arrive à échéance. L'assemblée générale décide à l'unanimité de renouveler son mandat de
commissaire aux comptes pour une durée d'un an. Son mandat prendra donc fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire
statuant sur les comptes clos au 31.12.2014 qui se tiendra en 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014101657/20.
(140120160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

120201

L

U X E M B O U R G

Centralis Immobilière S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 9-10, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 125.149.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014100851/9.
(140120893) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

Camping-Concept Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9841 Wahlhausen, 37, Akescht.

R.C.S. Luxembourg B 105.765.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014100879/10.
(140120842) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

Campria Capital S.A. S.P.F., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 11.447.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014100880/10.
(140120339) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

Stibbe Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 181.426.

<i>Extrait de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société tenue le 10 juillet 2014

1/ L'assemblée a décidé d'approuver la cession des trois mille cent vingt-cinq (3.125) parts sociales détenues par

l'associé Paul Tulcinsky S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social situé
au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 169788, à la société Jan Peeters S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant
son siège social situé au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 184742, avec effet au 10 juillet 2014.

En conséquence de cette cession de parts sociales, la société Jan Peeters S.à r.l., précitée, devient désormais associé

de la société et détient trois mille cent vingt-cinq (3.125) parts sociales dans la société.

2/ L'Assemblée a décidé de prendre acte de la démission de Paul Tulcinsky S.à r.l. de sa fonction de Gérant de la société

avec effet au 10 juillet 2014 et de nommer la société Jan Peeters S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit
luxembourgeois, ayant son siège social situé au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 184742, en qualité de Gérant de la société avec effet au 1

er

 juillet 2014 et ce pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Vanessa Lorreyte
<i>Le Mandataire

Référence de publication: 2014103512/25.
(140121852) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2014.

120202

L

U X E M B O U R G

Milort S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 130.452.

Les comptes annuels au 30 juin 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 juillet 2014.

<i>Pour: MILORT S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme

Référence de publication: 2014102406/14.
(140123851) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2014.

Chemtrade Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 183.212.

Acte de constitution publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 05.03.2014

EXTRAIT

Suite aux résolutions prises par l'associé unique en date du 15 juillet 2014, il résulte que:
- M. Mark Davis, né à Chicago (IL, USA), le 29 avril 1958 avec résidence professionnelle au 155 Gordon Baker Road,

Suite 300, Toronto, Ontario M2H 3N5, Canada, est nommé aux fonctions de gérant de classe B de la Société;

- M. Tamas Horvath, né à Pecs (Hongrie), le 5 novembre 1977 avec résidence professionnelle au 8-10, avenue de la

Gare, L-1610 Luxembourg, est nommé aux fonctions de gérant de classe A de la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Chemtrade Luxembourg Sàrl

Référence de publication: 2014105580/17.
(140126227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2014.

Multipharma S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 23, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 56.943.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 1 

er

 juillet 2014, statuant sur les comptes annuels

au 31 décembre 2012, que:

Sont réélus Administrateurs de la société et ceci jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en l'année

2019:

- Monsieur Peter KRANTZ, né le 23 mars 1963 à Vallentuna (Suède), demeurant au 6, quai Jean Charles, MC-98000

Monaco (Monaco)

- Madame Mireille GEHLEN, demeurant au 2, rue Stade J.-F. Kennedy, L-3502 Dudelange
- Monsieur Jean-Hugues DOUBET, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg
- Monsieur Kay-Christian KARSTADT, demeurant au 2, Marienstrasse, D-10117 Berlin (Allemagne)
Et réélu Réviseur d'Entreprises Agréé pour la même période:
- H.R.T. Révision S.A., avec siège social au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen
Est également réélu Président du Conseil d'Administration pour la même période:
- Monsieur Peter KRANTZ, né le 23 mars 1963 à Vallentuna (Suède), demeurant au 6, quai Jean Charles, MC-98000

Monaco (Monaco)

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2014102416/23.
(140122467) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2014.

120203

L

U X E M B O U R G

Getinge Holding Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 163.972.000,00.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 178.621.

EXTRAIT

La résolution suivante a été adoptée par l'associé unique en date du 30 juin 2014:
La personne suivante a été nommée en tant que gérant de catégorie B, avec effet au 26 juin 2014 et pour une durée

indéterminée:

- Monsieur Luc SUNNEN, né le 22 décembre 1961 à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant son adresse

professionnelle au 23, rue des Bruyères, L-1274 Howald, Grand-Duché de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 18 juillet 2014.

Référence de publication: 2014105747/17.
(140126476) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2014.

Gerona Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.000,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 162.387.

Il résulte d'une décision prise par l'associé unique de la Société en date du 15 juillet 2014 que:
- La démission de Monsieur Jean-Christophe Gladek de ses fonctions de gérant de catégorie A de la Société a été

acceptée avec effet au 4 juillet 2014.

- Monsieur John Wiseman, né le 22 août 1971 à Jersey, Royaume-Uni, avec adresse professionnelle au 13, Castle Street

St Helier, Jersey, JE4 5UT a été nommé gérant de catégorie B de la Société, avec effet au 7 juillet 2014 pour une durée
illimitée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 juillet 2014.

Pour extrait sincère et conforme
Sanne Group (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2014104034/18.
(140124304) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juillet 2014.

CEP D'or S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5429 Hëttermillen, 15, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 51.253.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 21 juin 2014, les mandats de Monsieur Nico Vesque, demeurant à

L-5451 Stadtbredimus, 72, Dicksstrooss et de Madame Marie-Madeleine Vesque, épouse Schmit, demeurant à L-6840
Machtum, 17, rue de Donven, administrateurs de la société ainsi que celui du commissaire aux comptes Madame Margot
Vesque, demeurant à L-6840 Machtum, 17, rue de Donven, sont arrivés à échéance. Sur proposition du conseil d'admi-
nistration, l'assemblée renouvelle les mandats de Monsieur Nico Vesque et de Madame Marie-Madeleine Vesque pour un
nouveau terme de trois ans. L'assemblée générale accepte la proposition du conseil d'administration de nommer Monsieur
Guido Zinnen, demeurant à L-4499 Limpach, 4, rue Centrale, comme commissaire aux comptes. Le mandat du commis-
saire aux comptes prendra fin lors de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2016.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Hëttermillen, le 21 juin 2014.

Pour copie sincère et conforme
<i>L'administrateur délégué

Référence de publication: 2014105610/19.
(140126672) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2014.

120204

L

U X E M B O U R G

Madera S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 137.549.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014101361/9.
(140120044) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

Maine Consulting S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 61.691.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014101363/10.
(140120708) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

Morgan Stanley Equity Derivative Services (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 17.217,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 148.168.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juillet 2014.

<i>Pour la société Morgan Stanley Equity Derivative Services (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2014101354/11.
(140120236) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

G.A.T.S. Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4123 Esch-sur-Alzette, 4, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 134.630.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 06 mai 2014

<i>Résolution n° 1

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide la prorogation du mandat

d'administrateur et d'administrateur-délégué de Mademoiselle Assia DERGUIANI, demeurant à F-57290 Fameck, 4, ave-
nue François Mitterrand, à compter du 03 juin 2013 pour une durée de six ans.

<i>Résolution n°2

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide la prorogation du mandat

d'administrateur et d'administrateur-délégué de la société OLEA CAPITAL INVEST S.A. (anciennement ELODEE S.A.),
sise à L-4123 Esch-sur-Alzette, 3, rue du Fossé, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B-77.619, à compter du 03 juin 2013 pour une durée de six ans.

<i>Résolution n°3

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide d'acter la démission des

fonctions d'administrateur et d'administrateur-délégué de Madame Nadine CARELLE.

Esch-sur-Alzette, le 06 mai 2014.

Pour extrait sincère et conforme à l'original
Fiduciaire C.G.S.
Signature

Référence de publication: 2014105744/24.
(140126844) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2014.

120205

L

U X E M B O U R G

Alcove Europe Two S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 155.434.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014102787/9.
(140122052) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2014.

Alce Investment I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 118.635.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Alce Investment I S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2014102781/11.
(140122202) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2014.

Apollo 11 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 169.556.

<i>Extrait de l'assemblée générale annuelle des associés tenue à Luxembourg en date du 8 juillet 2014

L'assemblée décide de renouveler le mandat de la société PricewaterhouseCoopers, ayant son siège social au 400,

route d'Esch, L-1471 Luxembourg, en tant que réviseur d'entreprises agréé.

Le mandat du réviseur d'entreprises agréé ainsi nommé viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle,

qui se tiendra en 2015, approuvant les comptes annuels au 31 décembre 2014.

Pour extrait conforme
Apollo 11 S.à r.l.

Référence de publication: 2014102808/14.
(140121830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2014.

Aramis International 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 35, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 137.846.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue en date du 31 mars 2014 que:
1. L'assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire à la liquidation, approuve le rapport du

liquidateur ainsi que les comptes de liquidation.

2. L'assemblée donne décharge pleine et entière au Liquidateur et au Commissaire à la liquidation, en ce qui concerne

l'exécution de leur mandat.

3. L'assemblée a décidé la clôture de la liquidation et constate la dissolution définitive de la société;
4. Les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans au siège de la société, et en outre

que les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers ou aux associés qui ne se seraient pas présentés à la
clôture de la liquidation seront déposés au même ancien siège social au profit de qui il appartiendra.

Luxembourg, le 11 juillet 2014.

Signature
<i>Le Liquidateur

Référence de publication: 2014102811/20.
(140121720) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2014.

120206

L

U X E M B O U R G

CS Investment Funds 2, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 124.019.

In the year two thousand and fourteen, on the third day of the month of July;
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned,

was held

an extraordinary general meeting of the shareholders (the “Meeting”) of Credit Suisse SICAV One (Lux) (hereafter

referred to as the “Company”), a société d'investissement à capital variable having its registered office at 5, rue Jean
Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Trade and Companies Registry of Lu-
xembourg, section B, under number 124019, incorporated pursuant to a deed of Me Paul BETTINGEN, notary residing
in Niederanven (Grand Duchy of Luxembourg), on 5 February 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, number 173 of 14 February 2007. The articles of incorporation of the Company were last amended
through a notarial deed dated 21 December 2011, drawn up by the undersigned notary and published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, number 573, page 27479, of 5 March 2012.

The Meeting elected as chairman, Mr. Rudolf KÖMEN, Director, Credit Suisse Fund Management S.A., with profes-

sional address at L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

The chairman appointed as secretary of the Meeting Mrs. Jacqueline SIEBENALLER, Director, Credit Suisse Fund

Management S.A., with professional address at L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

The Meeting elects as scrutineer Mr. Fernand SCHAUS, Director, Credit Suisse Fund Management S.A., with profes-

sional address at L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

The bureau of the Meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the Meeting is the following:
1. Amendment of Article 1 “Name” in order to rename the Company from “Credit Suisse SICAV One (Lux)” to “CS

Investment Funds 2”;

2. Amendment of Article 5 “Capital and Certification of Shares” in order to introduce the possibility for the Company

to issue shares in dematerialised form and to remove the possibility to issue bearer shares. Further introduction of the
obligation for holders of bearer shares to convert these shares into registered or dematerialised shares, and of other
minor changes in order to align on the provisions of the law of 6 April 2013;

3. Amendment of Article 8 “U.S. Person” to “U.S. Matters” in order to update the articles of incorporation of the

Company in line with the requirements of the U.S. Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”), by introducing the
requirement for the shareholders and investors of the Company to provide certain information required under FATCA,
which may be disclosed by the Company or its management company to the U.S. internal revenue service (“IRS”).

II. The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their

shares are shown on an attendance list. This attendance list, signed ne varietur by the proxyholders of the represented
shareholders, by the bureau of the Meeting and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the
same time with the registration authorities.

III. The present Meeting was convened by notices containing the agenda sent by registered mail on 17 June 2014 to

the registered shareholders.

IV. The resolutions on the agenda require a quorum of 50% of the share capital of the Company and may only be

validly take if approved by at least 2/3 of the votes cast.

V. It appears from the attendance list that, out of the 49’333’105.41 shares in issue as at 3 July 2014, 33’970’850 shares

are present or represented, they represent 68% of the share capital of the company. There are 4’431 abstentions.

VI. As a result of the foregoing, the present Meeting is regularly constituted and may validly deliberate on the items of

the agenda.

After approval of the statements of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the Meeting

passed, after deliberation, the following resolution by unanimous vote:

<i>First resolution

The Meeting RESOLVES to amend article 1 of the Articles in order to amend the Company’s denomination from

“Credit Suisse SICAV One (Lux)” to “CS Investment Funds 2”.

<i>Second resolution

The Meeting RESOLVES to amend article 5 of the Articles, which shall henceforth be read as follows:
“The capital of the Company shall be represented by shares of no par value and shall at the time of establishment

amount to fifty thousand US Dollars (US Dollars 50.000). Thereafter, the capital of the Company will at all time be equal
to the total net assets of the Company as defined in Article 21 hereof.

120207

L

U X E M B O U R G

The minimum capital of the Company shall be at least the equivalent of one million two hundred and fifty thousand in

Euro (EUR 1,250,000.-) within a period of 6 months following the authorization of the Company.

The Board of Directors is authorized without limitation to issue further shares to be fully paid at any time in accordance

with Article 22 hereof without reserving for the existing shareholders a preferential right to subscription of the shares
to be issued.

The Board of Directors may delegate to any duly authorized Director or officer of the Company or to any other duly

authorized person, the duty of accepting subscriptions for delivering and receiving payment for such new shares.

Such shares may, as the Board of Directors shall determine, be of different classes and the proceeds of the issue of

one or more classes of shares be accounted for in subfunds (the “Subfunds”) or pools of assets established pursuant to
Article 21 hereof and shall invest in transferable securities and other investments permitted by the Law of 17 December
2010 corresponding to such geographical areas, industrial sectors or monetary zones, or such other areas or sectors,
including in units of other undertakings for collective investments as the Board of Directors shall from time to time
determine in respect of each Sub-fund.

The Board of Directors may further decide, in connection with each such Subfund or pool of assets to create and

issue new classes of shares within any Subfund that will be commonly invested pursuant to the specific investment policy
of the Subfund concerned but where a specific sales and redemption charge structure or hedging policy or currency
denomination or other distinguishing feature is applied to each class. For the purpose of determining the capital of the
Company, the assets and liabilities of the Subfund shall be allocated to the individual classes of shares. If not expressed in
Swiss franc respectively, they shall be converted into Swiss franc respectively and the capital shall be the total net assets
of all the classes.

Shares are issued in registered or dematerialised form. The Company reserves the right to reject any subscription

application for shares, whether in whole or in part, for any reason. Any bearer shares outstanding must be presented by
the holders thereof for conversion into registered or dematerialised shares as soon as possible, the costs of which may
be charged to the bearer shareholder. The Board of Directors may in its discretion decide whether to issue certificates
in respect of registered shares or not, unless expressly requested to issue certificates by the person recorded in the
register. Dematerialized shares may be held through collective depositories. In such cases, shareholders shall receive a
confirmation in relation to their shares from the depository of their choice (for example, their bank or broker), or shares
may be held by shareholders directly in a registered account kept for the Company and its shareholders by the Company’s
central administration. These shareholders will be registered by the central administration. Shares held by a depository
may be transferred to an account of the shareholder with the central administration or to an account with other depo-
sitories  approved  by  the  Company  or,  with  an  institution  participating  in  the  securities  and  fund  clearing  systems.
Conversely, shares held in a shareholder’s account kept by the central administration may at any time be transferred to
an account with a depository.

If a registered shareholder desires that more than one share certificate be issued for its shares, the cost of such

additional certificates may be charged to such shareholder. Share certificates shall be signed by two Directors. Both such
signatures may be either manual, or printed, or by facsimile.

However, one of such signatures may be by a person delegated to this effect by the Board of Directors. In such latter

case, it shall be manual. The Company may issue temporary share certificates in such form as the Board of Directors may
from time to time determine. The Company reserves the right to reject any subscription application for shares, whether
in whole or in part, at its own discretion for whatever reason.

Shares shall be issued only upon acceptance of the subscription and subject to payment of the price as set forth in

Article 22 hereof. The subscriber will, without undue delay, obtain delivery of definitive share certificates or a confirmation
of his shareholding.

Payments of dividends will be made to shareholders, at their addresses in the register of shareholders (the “Register

of Shareholders”).

All issued registered shares of the Company shall be inscribed in the Register of Shareholders in compliance with the

provisions of article 39 of the law of 10 August 1915, as may be amended from time to time, which shall be kept by the
Company or by one or more persons designated therefore by the Company and such Register of Shareholders shall
contain the name of each holder of inscribed shares, his residence or elected domicile so far as notified to the Company,
the number and class of shares held by him and the amount paid in on each such share. Every transfer of a registered
share shall be entered in the Register of Shareholders, and every such entry shall be signed by one or more officers of
the Company or by one or more persons designated by the Board of Directors.

Transfer of registered shares shall be effected (a) if share certificates have been issued, by inscription of the transfer

to be made by the Company upon delivering the certificate or certificates representing such shares to the Company along
with other instruments of transfer satisfactory to the Company, and (b), if no share certificates have been issued, by
written declaration of transfer to be inscribed in the Register of Shareholders, dated and signed by the transferor and
transferee, or by persons holding suitable powers of attorney to act therefore.

Every registered shareholder must provide the Company with an address to which all notices and announcements

from the Company may be sent. Such address will be entered in the Register of Shareholders.

120208

L

U X E M B O U R G

In the event that such shareholder does not provide such address, the Company may permit a notice to this effect to

be entered in the Register of Shareholders and the shareholder’s address will be deemed to be at the registered office
of the Company, or such other address as may be so entered by the Company from time to time, until another address
shall be provided to the Company by such shareholder. The shareholder may, at any time, change the address as entered
in the Register of Shareholders by means of a written notification to the Company at its registered office, or at such other
address as may be set by the Company from time to time.

If payment made by any subscriber results in the issue of a share fraction, such fraction shall be entered in the Register

of Shareholders. It shall not be entitled to vote but shall, to the extent the Company shall determine, be entitled to a
corresponding fraction of the dividend.”

<i>Third resolution

The Meeting RESOLVES to amend article 8, which shall henceforth be read as follows:

“ Art. 8. U.S. Matters. Whenever used in these Articles, U.S. person (the “U.S. Person”), subject to such applicable

law and to such changes as the Directors shall notify to shareholders, shall mean, a national or resident of the United
States of America or any of its territories, possessions or other areas subject to its jurisdiction, including the States and
the Federal District of Columbia (the “United States”) (including any corporation, partnership or other entity created or
organised in, or under the laws, of the United States or any political sub-division thereof), or any estate or trust, other
than an estate or trust the income of which from sources outside the United States (which is not effectively connected
with the conduct of a trade or business within the United States) is not included in gross income for the purpose of
computing United States federal income tax, provided, however, that the term “U.S. person” shall not include a branch
or agency of a United States bank or insurance company that is operating outside the United States as a locally regulated
branch or agency engaged in the banking or insurance business and not solely for the purpose of investing in securities
under the United States Securities Act 1933, as amended including (but without restriction) as described in section 7701
(a)(30) of the U.S. Internal Revenue Code of 1986, as amended.

Each Shareholder and each transferee of a Shareholder's interest in any Sub-fund shall furnish (including by way of

updates) to the Company, or any third party designated by the Company (a “Designated Third Party”), in such form and
at such time as is reasonably requested by the Company (including by way of electronic certification) any information,
representations, waivers and forms relating to the Shareholder (or the Shareholder's direct or indirect owners or account
holders) as shall reasonably be requested by the Company or the Designated Third Party to assist it in obtaining any
exemption, reduction or refund of any withholding or other taxes imposed by any taxing authority or other governmental
agency (including withholding taxes imposed pursuant to the Hiring Incentives to Restore Employment Act of 2010, or
any similar or successor legislation or intergovernmental agreement, or any agreement entered into pursuant to any such
legislation or intergovernmental agreement) upon the Company, amounts paid to the Company, or amounts allocable or
distributable by the Company to such Shareholder or transferee. In the event that any Shareholder or transferee of a
Shareholder's interest fails to furnish such information, representations, waivers or forms to the Company or the Desi-
gnated Third Party, the Company or the Designated Third Party shall have full authority to take any and all of the following
actions:

a) Withhold any taxes required to be withheld pursuant to any applicable legislation, regulations, rules or agreements;
b) Redeem the Shareholder's or transferee's interest in any Subfund as set out in Article 7;
c) Form and operate an investment vehicle organized in the United States that is treated as a “domestic partnership”

for purposes of section 7701 of the Internal Revenue Code of 1986, as amended and transfer such Shareholder's or
transferee's interest in any Subfund or interest in such Subfund assets and liabilities to such investment vehicle. If requested
by the Company or the Designated Third Party, the Shareholder or transferee shall execute any and all documents,
opinions, instruments and certificates as the Company or the Designated Third Party shall have reasonably requested or
that are otherwise required to effectuate the foregoing. Each Shareholder hereby grants to the Company or the Desi-
gnated Third Party a power of attorney, coupled with an interest, to execute any such documents, opinions, instruments
or certificates on behalf of the Shareholder, if the Shareholder fails to do so.

The Company or the Designated Third Party may disclose information regarding any Shareholder (including any in-

formation provided by the Shareholder pursuant to this Article) to any person to whom information is required or
requested to be disclosed by any taxing authority or other governmental agency including transfers to jurisdictions which
do not have strict data protection or similar laws, to enable the Company to comply with any applicable law or regulation
or agreement with a governmental authority. Each Shareholder hereby waives all rights it may have under applicable bank
secrecy, data protection and similar legislation that would otherwise prohibit any such disclosure and warrants that each
person whose information it provides (or has provided) to the Company or the Designated Third Party has been given
such information, and has given such consent, as may be necessary to permit the collection, processing, disclosure, transfer
and reporting of their information as set out in this Article and this paragraph.

The Company or the Designated Third Party may enter into agreements with any applicable taxing authority (including

any agreement entered into pursuant to the Hiring Incentives to Restore Employment Act of 2010, or any similar or
successor legislation or intergovernmental agreement) to the extent it determines such an agreement is in the best interest
of the Company or any Shareholder.”

120209

L

U X E M B O U R G

Nothing else being on the agenda, and nobody wishing to address the Meeting, the meeting was closed.

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at approximately one thousand two hundred and fifty Euros (1,250.- EUR).

<i>Statement

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English.

WHEREUPON the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present
original deed.

Signé: R. KÖMEN, J. SIEBENALLER, F. SCHAUS, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 8 juillet 2014 LAC/2014/31747. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 11 juillet 2014.

Référence de publication: 2014100870/193.
(140120614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

Digital Services XXXII (GP) S.à r.l, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 188.576.

STATUTES

In the year two thousand and fourteen, on the eighteenth day of June.
Before us Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Digital Services XXXII S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of Grand

Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg,
the registration of which with the Luxembourg Trade and Companies’ Register is pending,

here represented by Mr. Luis AGUERRE ENRÍQUEZ, Doctor en Derecho, residing in Luxembourg,, by virtue of a

proxy, given in Berlin, Germany, on 18. June 2014, and in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 18. June 2014.

Said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to

this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such  appearing  party  has  requested  the  officiating  notary  to  enact  the  deed  of  incorporation  of  a  private  limited

company (société à responsabilité limitée) which it wishes to incorporate with the following articles of association:

A. Name - Purpose - Duration - Registered office

Art. 1. Name - Legal Form. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name

Digital Services XXXII (GP) S.à r.l. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915
concerning commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.

Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign

companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio in view of its realisation by sale, exchange or otherwise.

2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it

holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the
Company.

2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by

issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.

2.4 The Company may also act as a partner with unlimited or limited liability for the debts and obligations of any

Luxembourg or foreign entity.

120210

L

U X E M B O U R G

2.5 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities

which it considers useful for the accomplishment of these purposes.

Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of

managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution
of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution

of the board of managers.

4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances

or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
traordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwiths-
tanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

B. Share capital - Shares

Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), represented by twelve

thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.

5.2 The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.3 The Company may redeem its own shares.

Art. 6. Shares.
6.1 The Company’s share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of

the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.

Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection

by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.

7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall

appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.

7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given

by the shareholders at a majority of three quarters of the share capital.

7.5 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of

the transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

7.6 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject

to the approval of such transfer given by the surviving shareholders at a majority of three quarters of the share capital.
Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving
spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.

C. Decisions of the shareholders

Art. 8. Collective decisions of the shareholders.
8.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles

of association.

8.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
8.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise

conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case,

120211

L

U X E M B O U R G

each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his
vote in writing.

8.4 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of

shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by
the sole shareholder.

Art. 9. General meetings of shareholders. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, at least

one general meeting of shareholders shall be held within six (6) months of the end of each financial year in Luxembourg
at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the convening notice of such meeting.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices
of meeting. If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived
any convening requirement, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 10. Quorum and vote.
10.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
10.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company’s

shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share
capital. If this majority is not reached in a first meeting or proposed written resolution, the shareholders may be convened
a second time with the same agenda or receive such proposed written resolution a second time by registered letter,
decisions are validly adopted in so far as they are adopted by a majority of the votes validly cast whichever is the fraction
of the share capital represented.

Art. 11. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.

Art. 12 Amendments of the articles of association. Any amendment of the articles of association requires the approval

of (i) a majority of shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.

D. Management

Art. 13. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
13.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers

form a board of managers.

13.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not

expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of
association is to be construed as a reference to the “sole manager”.

13.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any

actions necessary or useful to fulfil the Company’s corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the
Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.

Art. 14. Appointment, removal and term of office of managers.
14.1 The manager(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remune-

ration and term of office.

14.2 The managers shall be appointed and may be removed from office at any time, with or without cause, by a decision

of the shareholders representing more than half of the Company’s share capital.

14.3 The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two (2) different classes, being class A

managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant
shareholders resolutions and the managers be identified with respect to the class they belong.

Art. 15. Vacancy in the office of a manager.
15.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or

otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the  replaced  manager  by  the  remaining  managers  until the  next meeting  of  shareholders which  shall resolve on the
permanent appointment, in compliance with the applicable legal provisions.

15.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company’s sole manager, such vacancy must be filled without undue

delay by the general meeting of shareholders.

Art. 16. Convening meetings of the board of managers.
16.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held

at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.

16.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four (24) hours at

least in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager

120212

L

U X E M B O U R G

in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document
being sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location
determined in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.

16.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive

any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of
managers.

Art. 17. Conduct of meetings of the board of managers.
17.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not

need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

17.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers.
In his absence, the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority

of managers present or represented at any such meeting.

17.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either

in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.

17.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other

means of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis
and allowing an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a
participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.

17.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or

represented at a meeting of the board of managers.

17.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,

if any, shall not have a casting vote. In the event where the general meeting of shareholders has appointed different classes
of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only be validly
taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which may be
represented).

17.7. The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in

writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be
the date of the last signature.

Art. 18. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
18.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by

the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. In the event the general meeting of
shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) under the joint
signature of one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation). Copies or excerpts
of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if any, or
by any two (2) managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers
(namely class A manager and class B manager) under the joint signatures of one (1) class A manager and one (1) class B
manager (including by way of representation).

18.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or

excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.

Art. 19. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the

signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers;
in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers
and class B managers), the Company will only be validly bound by the joint signatures of at least one (1) class A manager
and one (1) class B manager (including by way of representation) or (ii) by the joint signatures or the sole signature of
any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such
delegation.

E. Audit and supervision

Art. 20. Auditor(s).
20.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company

shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.

20.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting

of shareholders.

20.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.

120213

L

U X E M B O U R G

20.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d’entreprises agréé

(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies’ register and the
accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.

20.5. An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its

approval.

F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends

Art. 21. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end

on the thirty-first of December of the same year.

Art. 22. Annual accounts and allocation of profits.
22.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of

the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.

22.2. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve.

This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten
per cent (10%) of the share capital of the Company.

22.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the

contributing shareholder agrees with such allocation.

22.4 In case of a share capital reduction, the Company’s legal reserve may be reduced in proportion so that it does

not exceed ten per cent (10%) of the share capital.

22.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the

remainder of the Company’s profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.

22.6 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.

Art. 23. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
23.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared

by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may
not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable
reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles
of association do not allow to be distributed.

23.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the share-

holders subject to the provisions of the Law and these articles of association.

G. Liquidation

Art. 24. Liquidation.
24.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the

liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders
deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided,
the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the
Company.

24.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the shareholders in proportion to the number of shares of the Company held by them.

H. Final clause - Governing law

Art. 25. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance

with the Law.

<i>Transitional provisions

1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 31 December

2014.

2. Interim dividends may be distributed during the Company’s first financial year.

<i>Subscription and payment

The twelve thousand five hundred (12,500) shares issued have been subscribed by Digital Services XXXII S.à r.l.,

aforementioned, for the price of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500).

The shares so subscribed are fully paid-up by a contribution in cash so that the amount of twelve thousand five hundred

euro (EUR 12,500) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

The total contribution in the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) is entirely allocated to the

share capital.

120214

L

U X E M B O U R G

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be

borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately one thousand Euros (EUR
1,000.-).

<i>Resolution of the sole shareholder

The incorporating shareholder, representing the entire share capital of the Company and having waived any convening

requirements, has thereupon passed the following resolutions:

1. The address of the registered office of the Company is set at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of

Luxembourg.

2. The following person is appointed as class A manager of the Company for an unlimited term:
- Mr Christian Senitz, born in Aschersleben, Germany, on 27 January 1978, professionally residing at Johannisstrasse

20, D-10117 Berlin.

The following person is appointed as class B manager of the Company for an unlimited term:
- Mr Ulrich Binninger, born in Trier, Germany, on 30 August 1966, professionally residing at 19, rue des Lilas, L-8035

Strassen, Luxembourg.

<i>Statement

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,

this deed is worded in English followed by a German translation; at the request of the same appearing party and in case
of divergence between the English and the German text, the English version shall prevail.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this

document.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name

and residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahr zweitausendvierzehn, am achtzehnten Juni.
Vor uns, Carlo WERSANDT, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

IST ERSCHIENEN:

Digital Services XXXII S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), gegründet

und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Groß-
herzogtum Luxemburg, deren Eintragung im Luxemburger Handels-und Gesellschaftsregister noch aussteht,

hier vertreten durch Herrn Luis AGUERRE ENRÍQUEZ, Doctor en Derecho, wohnhaft in Luxemburg, gemäß einer

Vollmacht ausgestellt in Berlin, Deutschland, am 18. Juni 2014 und in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, am 18.
Juni 2014.

Besagte Vollmacht, welche vom Bevollmächtigten der erschienenen Partei und dem unterzeichnenden Notar ne vari-

etur paraphiert wurde, wird der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.

Die erschienene Partei hat den amtierenden Notar ersucht, die Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung

(société à responsabilité limitée) zu beurkunden, welche sie mit der folgenden Satzung gründen möchte:

A. Name - Zweck - Dauer - Sitz

Art. 1. Name - Rechtsform. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée)

mit dem Namen Digital Services XXXII (GP) S.à r.l. (die „Gesellschaft”), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom
10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung
unterliegt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Ge-

sellschaften, sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung
oder auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung,
Kontrolle und Entwicklung ihrer Beteiligungen im Hinblick auf deren Verwertung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige
Art.

2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder

Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören Garantien geben,
Sicherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.

2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere

durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und
Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheinen bzw. Wertpapieren.

120215

L

U X E M B O U R G

2.4 Die Gesellschaft kann auch als Gesellschafterin für die Schulden und Verpflichtungen jeglicher luxemburgischen

und ausländischen Gesellschaft mit unbeschränkter oder beschränkter Haftung handeln.

2.5 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur vorneh-

men, sowie solche, welche das geistige Eigentum betreffen oder im Zusammenhang mit Grundeigentum stehen, und die
ihr zur Erreichung dieser Zwecke förderlich erscheinen.

Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden,

welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird.

Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Rates der Geschäftsführer

verlegt werden. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderli-
chen Art und Weise gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer im

Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.

4.4 Sollte der Rat der Geschäftsführer entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale

Entwicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an
ihrem  Gesellschaftssitz  beeinträchtigen  könnten,  so  kann  der  Gesellschaftssitz  bis  zur  endgültigen  Beendigung  dieser
außergewöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben
keine Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes
eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1  Das  Gesellschaftskapital  der  Gesellschaft  beträgt  zwölftausendfünfhundert  Euro  (EUR  12.500)  bestehend  aus

zwölftausendfünfhundert (12.500) Anteilen mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Anteil.

5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-

zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.

5.3 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen.

Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit jeweils dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht über-

schreiten darf.

6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs, die Insolvenz

oder ein vergleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.

Art. 7. Anteilsregister - Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden

kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.

7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten

wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft
ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.

7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.
7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern mit

einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden.

7.5 Jede Übertragung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten gemäß Artikel 1690 des Code Civil

wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung zugestimmt
hat.

7.6 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters an neue Gesellschafter nur mit Zustimmung von

Gesellschaftern mit einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden. Eine derartige Zu-
stimmung ist nicht erforderlich, wenn die Anteile Eltern, Nachkommen oder dem/der überlebenden Ehepartner/in oder
jedem anderen gesetzlichen Erben des verstorbenen Gesellschafters übertragen werden.

120216

L

U X E M B O U R G

C. Entscheidungen der Gesellschafter

Art. 8. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
8.1 Die Gesellschafterversammlung ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch das Gesetz und diese Satzung

ausdrücklich vorbehalten sind.

8.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.
8.3 Falls und solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, dürfen gemeinsame Ent-

scheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung vorbehalten wären, schriftlich gefasst werden. In diesem
Fall erhält jeder Gesellschafter den Text der zu fassenden Beschlüsse oder Entscheidungen in ausformulierter Form und
übt sein Stimmrecht schriftlich aus.

8.4 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschriften

des Abschnitts XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jede Bezugnahme auf die „Gesell-
schafterversammlung“ in der vorliegenden Satzung als Bezugnahme auf den Alleingesellschafter, je nach Zusammenhang
und soweit anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingesellschafter
ausgeübt.

Art. 9. Gesellschafterversammlung. Falls die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, muss jährlich

innerhalb von sechs (6) Monaten vor dem Ende des Geschäftsjahres mindestens eine Gesellschafterversammlung in Lu-
xemburg am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort abgehalten werden, wie in der Einberufungsbekanntmachung
zu dieser Versammlung genauer bestimmt. Andere Gesellschafterversammlungen finden an dem Ort und zu der Zeit statt,
welche in der entsprechenden Einberufungsbekanntmachung genauer bestimmt werden. Falls alle Gesellschafter in einer
Versammlung anwesend oder vertreten sind und auf sämtliche Einberufungsformalitäten verzichtet haben, kann die Ge-
sellschafterversammlung auch ohne vorherige Ankündigung oder Veröffentlichung abgehalten werden.

Art. 10. Quorum und Abstimmung.
10.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.
10.2 Vorbehaltlich anderer Regelungen dieser Satzung oder des Gesetzes, die ein höheres Mehrheitsverhältnis vor-

sehen, bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von Gesellschaftern, die mehr als die
Hälfte des Gesellschaftskapitals halten. Falls diese Mehrheit in einer ersten Gesellschafterversammlung oder einer ersten
schriftlichen Konsultation der Gesellschafter nicht erreicht wird, können die Anteilseigner ein weiteres Mal mit derselben
Tagesordnung einberufen werden oder per Einschreiben dieselben schriftlichen Beschlussvorschläge erhalten und Ent-
scheidungen werden wirksam mit der Mehrheit der wirksam abgegebenen Stimmen gefasst, unabhängig vom Anteil des
durch sie vertretenen Gesellschaftskapitals.

Art. 11. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.

Art. 12. Änderung der Satzung. Eine Änderung der Satzung erfordert die Zustimmung (i) einer Mehrheit der Gesell-

schafter, (ii) die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertritt.

D. Geschäftsführung

Art. 13. Befugnisse des alleinigen Geschäftsführers - Zusammensetzung und Befugnisse des Rates der Geschäftsführer
13.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Ge-

schäftsführer hat, bilden diese einen Rat der Geschäftsführer.

13.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „alleiniger Ge-

schäftsführer“ nicht ausdrücklich verwendet wird, ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Rat der Geschäftsführer“
als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer“ auszulegen.

13.3 Der Rat der Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, im Namen der Gesellschaft zu handeln

und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.

Art. 14. Ernennung, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
14.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung ernannt, welche ihre Bezüge und

Amtszeit festlegt.

14.2 Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund durch einen Beschluss von Gesellschaftern, die mehr als die

Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, ernannt oder abberufen werden.

14.3 Die Gesellschafterversammlung kann die Ernennung von Geschäftsführern zwei (2) unterschiedlicher Kategorien

beschließen, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Eine solche Klassifizierung
der Geschäftsführer muss ordnungsgemäß im Protokoll der betreffenden Gesellschafterbeschlüsse festgehalten und die
Geschäftsführer der Kategorie, der sie angehören, zugeordnet werden.

Art. 15. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
15.1 Scheidet ein Geschäftsführer durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Insolvenz, Rücktritt oder aus einem anderen Grund

aus seinem Amt aus, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen die ur-

120217

L

U X E M B O U R G

sprüngliche Amtszeit nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesellschafterversammlung ausgefüllt werden,
welche im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die endgültige Ernennung entscheidet.

15.2 Für  den  Fall,  dass  der  alleinige  Geschäftsführer aus  seinem Amt  ausscheidet, muss die  frei gewordene  Stelle

unverzüglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.

Art. 16. Einladung zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
16.1 Der Rat der Geschäftsführer versammelt sich auf Einberufung eines beliebigen Geschäftsführers. Die Sitzungen

des Rates der Geschäftsführer finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.

16.2  Die  Geschäftsführer  werden  mindestens  vierundzwanzig  (24)  Stunden  vor  dem  für  die  Sitzung  anberaumten

Zeitpunkt zu jeder Sitzung des Rates der Geschäftsführer schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe
der Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Geschäftsführer
schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abgege-
ben haben, wobei eine Kopie eines solchen unterzeichneten Dokuments ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung
zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss
des Rates der Geschäftsführer bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.

16.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle

Einladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Rates
der Geschäftsführer diesen zugestimmt und diese unterzeichnet haben.

Art. 17. Durchführung von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
17.1 Der Rat der Geschäftsführer kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Rat der Ge-

schäftsführer kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise selbst ein Geschäftsführer sein muss
und der für die Protokollführung der Sitzungen des Rates der Geschäftsführer verantwortlich ist.

17.2 Sitzungen des Rates der Geschäftsführer werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Rates der Ge-

schäftsführer geleitet. In dessen Abwesenheit kann der Rat der Geschäftsführer einen anderen Geschäftsführer durch
einen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Mitglieder als Vorsitzenden pro tempore ernennen.

17.3 Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer teilnehmen, indem er einen anderen

Geschäftsführer schriftlich, per Faxschreiben, EMail oder durch ein anderes vergleichbares Kommunikationsmittel be-
vollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Geschäftsführer kann einen
oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.

17.4 Eine Sitzung des Rates der Geschäftsführer kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein

anderes Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu
hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel
ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung gilt als am Sitz der Ge-
sellschaft abgehalten.

17.5 Der Rat der Geschäftsführer kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest die Mehrheit seiner

Mitglieder in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.

17.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Rates der Geschäftsführer

teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden,
hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme. Sofern die Gesellschafterversammlung jedoch unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden Beschlüsse des Rates der Geschäftsführer nur dann wirksam gefasst, wenn sie von der Mehrheit
der Geschäftsführer einschließlich mindestens eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsführers der
Kategorie B (oder deren Vertreter) gefasst werden.

17.7 Der Rat der Geschäftsführer kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung,

per Faxschreiben, E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Jeder Geschäftsführer kann seine
Zustimmung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreffenden
Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.

Art. 18. Protokoll von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer - Protokoll der Entscheidungen des alleinigen Ge-

schäftsführers.

18.1 Das Protokoll einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer wird vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer,

falls vorhanden, oder, im Falle seiner Abwesenheit, vom Vorsitzenden pro tempore und dem Schriftführer (falls vorhan-
den) oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche
Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kate-
gorie B), werden solche Protokolle von einem (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einem (1) Geschäftsführer der
Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsver-
fahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer, falls
vorhanden, oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer

120218

L

U X E M B O U R G

der Kategorie B), werden solche Kopien oder Auszüge von einem (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einem (1)
Geschäftsführer der Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet.

18.2 Die Entscheidungen des alleinigen Geschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom alleinigen

Geschäftsführer unterzeichnet wird. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet.

Art. 19. Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Um-

ständen  (i)  durch  die  Unterschrift  des  alleinigen  Geschäftsführers  oder,  für  den  Fall,  dass  die  Gesellschaft  mehrere
Geschäftsführer hat, durch die gemeinsame Unterschrift von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern wirksam verpflichtet;
sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäfts-
führer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B), wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift
mindestens eines (1) Geschäftsführers der Kategorie A und eines (1) Geschäftsführers der Kategorie B (oder deren
Vertreter) oder (ii) durch die gemeinsamen Unterschriften oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/denen
eine Unterschriftsbefugnis durch den Rat der Geschäftsführer übertragen worden ist, wirksam verpflichtet.

E. Aufsicht und Prüfung der Gesellschaft

Art. 20. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
20.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der

Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)). Die Gesellschafterversammlung
ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.

20.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
20.3 Der Rechnungsprüfer hat ein unbeschränktes Recht der permanenten Überprüfung und Kontrolle aller Geschäfte

der Gesellschaft.

20.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember

2002  betreffend  das  Handelsregister  und  die  Buchhaltung  und  den  Jahresabschluss  von  Unternehmen,  in  der  jeweils
gültigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseur(s) d’entreprises agréé(s)) ernennen, entfällt
die Funktion des Rechnungsprüfers.

20.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die

Gesellschafterversammlung abberufen werden.

F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinne - Abschlagsdividenden

Art. 21. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am

einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

Art. 22. Jahresabschluss und Gewinne.
22.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Rat der Geschäftsführer erstellt im

Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und
Verlustrechnung.

22.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage

der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.

22.3  Durch  einen  Gesellschafter  erbrachte  Einlagen  in  Rücklagen  können  mit  Zustimmung  dieses  Gesellschafters

ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.

22.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage entsprechend herabgesetzt

werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.

22.5 Auf Vorschlag des Rates der Geschäftsführer bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den ge-

setzlichen  Vorschriften  und  den  Bestimmungen  dieser  Satzung,  wie  der  verbleibende  Bilanzgewinn  der  Gesellschaft
verwendet werden soll.

22.6 Ausschüttungen an die Gesellschafter erfolgen proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehalt-

enen Anteile.

Art. 23. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
23.1 Der Rat der Geschäftsführer kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche

vom Rat der Geschäftsführer vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur
Verfügung stehen. Der ausschüttbare Betrag darf nicht die Summe der seit dem Ende des vergangenen Geschäftsjahres
angefallenen Gewinne, gegebenenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne und ausschüttbare Rücklagen, beziehungs-
weise vermindert durch vorgetragene Verluste und Summen, die einer Rücklage zugeführt werden, welche nach dem
Gesetz von 1915 oder dieser Satzung nicht ausgeschüttet werden darf, übersteigen.

23.2 Das Agio, andere Kapitalreserven oder andere ausschüttbare Rücklagen können im Einklang mit den Bestimmun-

gen des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

120219

L

U X E M B O U R G

G. Liquidation

Art. 24. Liquidation.
24.1 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Liquidation durch einen

oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, die über die Auflö-
sung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit nichts anderes
bestimmt wird, haben die Liquidatoren die weitestgehenden Rechte für die Verwertung der Vermögenswerte und die
Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

24.2 Der sich nach Verwertung der Vermögenswerte und Tilgung der Verbindlichkeiten ergebende Überschuss wird

an die Gesellschafter proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehaltenen Anteile verteilt.

H. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht

Art. 25. Anwendbares Recht. Für alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten gelten die Regelungen des

Gesetzes von 1915.

<i>Übergangsbestimmungen

1. Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember

2014.

2. Abschlagsdividenden können auch während des ersten Geschäftsjahres der Gesellschaft ausgeschüttet werden.

<i>Zeichnung und Zahlung

Die zwölftausendfünfhundert (12.500) ausgegebenen Anteile wurden von Digital Services XXXII S.à r.l., vorbenannt,

zum Preis von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) gezeichnet.

Die Einlage für so gezeichnete Anteile wurde vollständig in bar erbracht, so dass der Gesellschaft ein Betrag in Höhe

von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) zur Verfügung steht, was dem unterzeichnenden Notar nachgewiesen
wurde.

Die gesamte Einlage in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) wird vollständig dem Gesellschaftskapital

zugeführt.

<i>Auslagen

Die der Gesellschaft aufgrund oder im Zusammenhang mit ihrer Gründung entstandenen Kosten, Gebühren, Honorare

und Auslagen werden auf eintausend Euro (EUR 1.000) geschätzt.

<i>Beschlüsse des Alleingesellschafters

Der Gründungsgesellschafter, welcher das gesamte Gesellschaftskapital repräsentiert und welcher auf eine formelle

Einberufungsbekanntmachung verzichtet, hat daraufhin folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Sitz der Gesellschaft ist in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
2. Die folgende Person wird für unbegrenzte Zeit als Geschäftsführer der Kategorie A der Gesellschaft ernannt:
- Herr Christian Senitz, geboren am 27. Januar 1978 in Aschersleben, Deutschland, geschäftsansässig in Johannisstraße

20, D-10117 Berlin.

Die folgende Person wird für unbegrenzte Zeit als Geschäftsführer der Kategorie B der Gesellschaft ernannt:
- Herr Ulrich Binninger, geboren am 30. August 1966 in Trier, Deutschland, geschäftsansässig in 19, rue des Lilas,

L-8035 Strassen, Luxemburg.

<i>Erklärung

Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache beherrscht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende

Urkunde auf Verlangen der erschienenen Partei auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung;
auf Verlangen besagter erschienener Partei und im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen
Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.

WORÜBER diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen wurde.
Die vorstehende Urkunde ist dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei, welcher dem Notar mit Namen, Vorn-

amen und Wohnsitz bekannt ist, verlesen und vom Notar gemeinsam mit diesem Bevollmächtigten unterzeichnet worden.

Signé: L. AGUERRE ENRIQUEZ, C. WERSANDT
Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 juin 2014. LAC/2014/28995. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 8 juillet 2014.

Référence de publication: 2014103032/578.
(140121790) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2014.

120220

L

U X E M B O U R G

Queensgate Investments II s.à R.L., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 15.000,00.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 188.720.

STATUTES

In the year two thousand and fourteen, on the twentieth day of June,
before us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

Queensgate  Investments  LLP,  a  limited  liability  partnership  organized  under  the  laws  of  England  and  Wales,  with

registered office at 22-23 Old Burlington Street, London, W1S 2JJ, United Kingdom, registered with the Registrar of
Companies for England and Wales under number OC367000, (the Founding Shareholder), represented by Joey Wong
Thomas in her capacity as authorized signatory,

here represented by Mister Gianpiero SADDI, private employee, with professional address in Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on June 19, 2014.

Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the Founding Shareholder and by the notary,

will remain attached to the present deed to be registered with it.

The proxyholder of the Founding Shareholder requested the notary to record the incorporation of a private limited

liability company (société à responsabilité limitée) whose articles of association shall read as follows:

“ARTICLES OF ASSOCIATION

Art. 1. Definitions. Unless the context otherwise requires, the following terms shall be construed as follows:

AIFM Law

means the Luxembourg law dated July 12, 2013 transposing the Directive 2011/61/EU of
the European Parliament and of the Council of June 8, 2011 on Alternative Investment Fund
Managers, as amended from time to time.

Articles

means these articles of association of the Company, as amended from time to time.

Board

means the board of managers of the Company, if more than one (1) Manager have been
appointed.

Business Day

means any day (other than a Saturday or Sunday) on which commercial banks are usually
open for business in the Grand Duchy of Luxembourg.

Chairman

means the chairman of the Board from time to time.

Company

means Queensgate Investments II S.à r.l.

Company Law

means the Luxembourg law dated August 10, 1915 on commercial companies, as amended
from time to time.

General Meeting

means the general meeting of the Shareholder(s).

Managers

means the persons appointed as such by the General Meeting and Manager means any of
them.

Shareholders

means the persons registered in the register of Shareholders of the Company, in application
of Article 185 of the Company Law, as the holders of the Shares from time to time and
Shareholder means any of them.

Shareholders Circular
Resolutions

has the meaning given to it in Article 11.

Shares

means the shares in registered form in the share capital of the Company having a par value
of one Pound Sterling (GBP 1.-) and Share means any of them.

Sole Manager

means the sole manager of the Company.

Sole Shareholder

means the only person registered in the register of Shareholders of the Company as the
only holder of the Shares from time to time, in application of Article 185 of the Company
Law.

Art. 2. Form and name. The name of the Company is “Queensgate Investments II S.à r.l.” The Company is a private

limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the present Articles, the Company Law and the
relevant legislation.

Art. 3. Corporate objects. The purpose of the Company is to act as investment manager for one (1) or more alternative

investment funds, regulated or not, established in Luxembourg or in any other member state of the European Union, in
accordance with the provisions of the AIFM Law.

120221

L

U X E M B O U R G

The Company may acquire, hold, manage and dispose of participations and any interests, in Luxembourg or abroad,

in any companies and/or enterprises in any form whatsoever. The Company may acquire stock, shares and other parti-
cipation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments as well as, more generally, any
securities and financial instruments issued by any public or private entity, particularly by subscription, purchase and ex-
change. It may participate in the creation, development, management and control of any company and/or enterprise. It
may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any
nature or origin.

The Company may, except by way of public offer, borrow in any form and may proceed by private placement only to

the issue of bonds, notes, debentures or any kind of debt or equity securities.

The Company may lend funds including, without limitation, those resulting from any borrowings of the Company and/

or from the issue of any equity or debt securities of any kind, to its subsidiaries, affiliated companies and/or any other
companies or entities it deems fit.

The Company may also guarantee, grant security in favor of, or otherwise assist, any company in which it holds a direct

or indirect participation or which forms part of the Company's group. For its own benefit and that of any other company
or person, the Company may further guarantee, pledge, transfer and encumber or otherwise create any security over
some or all of its assets in order to guarantee its own obligations and those of any other company. For the avoidance of
doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial sector without having obtained the required
authorization.

The Company may further act as a general or limited member with unlimited or limited liability for the debts and

obligations of partnerships or similar entities.

The Company may use any technique and instrument to manage its investments efficiently and to protect itself against

the risks related to credit, to currency exchange exposure, to interest rates risks and any other type of risks.

The  Company  may,  for  its  own  account  as  well  as  for  the  account  of  third  parties,  carry  out  any  operation  and

transaction  (including,  without  limitation,  those  involving  real  estate  and  movable  property)  which  may  be  useful  or
necessary to the accomplishment of its purpose or which are directly or indirectly related to it.

Art. 4. Duration of the company. The Company is formed for an unlimited duration.

Art. 5. Registered office. The Company's registered office is established in the municipality of Luxembourg. The re-

gistered office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the General
Meeting adopted in the manner required for amendment to these Articles, as per Article 12 below. The registered office
may be transferred within the boundaries of the municipality of Luxembourg, by a resolution of the Board or, as the case
may be, by a decision of the Sole Manager.

The Board or, as the case may be, the Sole Manager, shall further have the right to set up branches, subsidiaries or

other offices wherever deemed appropriate, whether in or outside the Grand Duchy of Luxembourg.

The Board or, as the case may be, the Sole Manager, may consider that extraordinary political or military developments

or events are imminent or have occurred which would interfere with the normal activities of the Company at its registered
office or with the communication between such office and persons abroad. In such circumstances, the registered office
may be temporarily transferred abroad until complete cessation of these extraordinary circumstances. These temporary
measures shall have no effect on the nationality of the Company which, despite the temporary transfer of its registered
office, remains a Luxembourg company.

Art. 6. Share capital. The subscribed share capital of the Company is set at fifteen thousand Pound Sterling (GBP

15,000.-), represented by fifteen thousand (15,000) Shares having a par value of one Pound Sterling (GBP 1.-) each.

The subscribed share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the General Meeting

adopted in the manner required for amendment to these Articles, as per Article 12 below.

Art. 7. Shares. All Shares are in registered form, fully subscribed and entirely paid up.
A register of Shareholders will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any Share-

holder. Such register shall set forth the name of each Shareholder, his/her/its residence or elected domicile, the number
of Shares held by him/her/it, the amounts paid in on each Share, the transfer/subscription of Shares and the dates of such
transfer/subscription as well as any security rights granted on the Shares from time to time. Each Shareholder will notify
his/her/its address and any change thereof to the Company by registered mail.

The Company may rely on the last address received from a Shareholder. Ownership of the Shares will be established

by the entry in the register of Shareholders.

Certificates of these entries may be issued to the Shareholders and such certificates, if any, will be signed by the

Chairman or by any Manager or, as the case may be, the Sole Manager.

The Company will recognize only one (1) owner per Share. Where a Share is held by more than one (1) person, the

Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that Share until one (1) person has been designated
as sole owner vis-à-vis the Company. The same rule applies in case of a conflict between a usufruct holder (usufruitier)
and a bare owner (nu-propriétaire) or between a pledgor and a pledgee.

120222

L

U X E M B O U R G

The Company may repurchase or redeem its own Shares provided that the repurchased or redeemed Shares are

immediately cancelled and the subscribed share capital of the Company is reduced accordingly.

Art. 8. Transfer of shares. Shares are freely transferable among the Shareholders. Except if otherwise provided by law,

the transfer of Shares to third parties is subject to the prior written consent of the Shareholders representing at least
three-quarters (3/4) of the subscribed share capital of the Company. The transfer of Shares to third parties by reason of
a Shareholder's death must be approved by the Shareholders representing three-quarters (3/4) of the rights owned by
the survivors.

The transfer of Shares may be effected by a written declaration of transfer recorded in the register of Shareholders,

such declaration of transfer to be dated and executed by the transferor and the transferee, by persons holding the suitable
powers of attorney to do so, or in accordance with the provisions applying to the transfer of claims provided for under
Article 1690 of the Luxembourg Civil Code.

As evidence of the transfer, the Company may also accept instruments of transfer it deems sufficient to evidence the

consent of the transferor and the transferee.

Art. 9. Shareholders. The Company may have a Sole Shareholder or Shareholders. If the Company has only one (1)

Shareholder, any reference to the Shareholders in these Articles is a reference to the Sole Shareholder and the Sole
Shareholder assumes all powers conferred to the General Meeting.

Art. 10. Powers of the general meeting. Any regularly constituted General Meeting represents the entire body of

Shareholders. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to all operations of the Company.

In these Articles, decisions made, or powers exercised, by the General Meeting refer to decisions made, or powers

exercised, by the Sole Shareholder as long as the Company has only one (1) Shareholder. Decisions made by the Sole
Shareholder are documented by way of written minutes.

Art. 11. Annual general meeting - Other general meetings. In accordance with the Company Law, if the number of

Shareholders exceeds twenty-five (25), an annual General Meeting must be held at the Company's registered office or at
any other place within the municipality of the registered office as specified in the convening notice of the annual General
Meeting. The annual General Meeting must take place on the second Tuesday of September of each year at 2 p.m. If such
day is not a Business Day, the annual General Meeting shall be held on the next following Business Day.

Notwithstanding the above and in the absolute and final judgment of the Board or, as the case may be, the Sole Manager,

the annual General Meeting may be held abroad if exceptional circumstances so require.

Other General Meetings are held at the time and place specified in the respective convening notices.
If the number of Shareholders is twenty-five (25) or less, resolutions of the Shareholders are adopted at a General

Meeting or by way of circular resolutions (the Shareholders Circular Resolutions).

Where resolutions are adopted by way of Shareholders Circular Resolutions, each Shareholder must receive at his/

her/its address (as it appears in the register of Shareholders) the text of the resolutions to be passed, which the Share-
holder must execute. Shareholders Circular Resolutions must be executed by all the Shareholders in order to be valid
and binding. Once executed, they will be valid and binding in the same way as if they had been adopted by a duly convened
and held General Meeting and will bear the date of the last signature.

The Shareholders Circular Resolutions as well as the minutes of the General Meetings shall be kept at the Company's

registered office.

Art. 12. Convening notices, Quorum, Powers of attorney and vote. The Shareholders shall be convened to General

Meetings and Shareholders Circular Resolutions may be proposed at the initiative of (i) any Manager or, as the case may
be, the Sole Manager, (ii) the statutory auditor(s) (if any) or (iii) Shareholders representing more than one-half (1/2) of
the subscribed share capital of the Company.

Except in cases of emergency, the nature and circumstances of which shall be set forth in the convening notice of the

General Meeting, written convening notices to any General Meeting shall be sent to all Shareholders at least eight (8)
calendar days prior to the date of the General Meeting by registered mail to their address appearing in the register of
Shareholders held by the Company.

The  General  Meeting  may  be  held  without  prior  written  convening  notice  if  all  Shareholders  are  present  and/or

represented and consider themselves duly convened and informed of the agenda of the meeting.

A Shareholder may act at any General Meeting by appointing in writing another person, who need not be a Shareholder,

as his/her/its proxy, whether in original, by fax or e-mail to which an electronic signature (which is valid under Luxembourg
law) is affixed.

Any Shareholder may participate in a General Meeting by conference call, video conference or similar means of com-

munication whereby (i) all the Shareholders attending the General Meeting can be identified, (ii) all persons participating
in the General Meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the General Meeting is live and ongoing
and (iv) the Shareholders can properly deliberate. Participation in a General Meeting by those means is equivalent to
presence in person at such General Meeting.

120223

L

U X E M B O U R G

Resolutions to be adopted at General Meetings shall be passed by Shareholders representing more than one-half (1/2)

of the subscribed share capital of the Company. If this majority is not reached at the first General Meeting, the Shareholders
shall be convened by registered mail to a second General Meeting and the resolutions shall be adopted at the second
General Meeting by a majority of the votes cast, regardless of the proportion of subscribed share capital represented.

These Articles may be amended with the consent of a majority in number of Shareholders representing at least three-

quarters (3/4) of the subscribed share capital of the Company.

Any change in the nationality of the Company and any increase of the Shareholders' commitments in the Company

require the unanimous consent of the Shareholders.

Each Share entitles to one (1) vote at General Meetings.

Art. 13. Management. The Company shall be managed by one (1) or more Manager(s) who need not be Shareholders.

If more than one (1) Manager are appointed, they together constitute the Board.

Managers are appointed by the General Meeting. The General Meeting shall also determine the number of Managers,

their remuneration and the term of their office, if any. A Manager may be removed with or without cause and/or replaced,
at any time, by a resolution adopted by the General Meeting.

Art. 14. Meetings of the board. The Board must appoint a Chairman among its members and may also designate a

secretary.

The Chairman chairs all meetings of the Board. In his/her absence, the other present and/or represented Managers

will, by a simple majority vote, appoint another Chairman pro tempore for the relevant meeting.

The secretary, who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board, need not be a Manager.
The Chairman, or any Manager, calls the meetings of the Board, which shall take place at the location indicated in the

convening notice of the meeting.

Except in cases of emergency, the nature and circumstances of which shall be set forth in the convening notice of the

meeting of the Board, written convening notices to a meeting of the Board shall be sent to all Managers at least twenty-
four (24) hours prior to the date set for such meeting.

No written convening notice is required (i) if all Managers are present and/or represented at the meeting and consider

themselves duly convened and informed of the agenda of the meeting or (ii) for any meeting held at a time and place
previously determined in a resolution adopted by the Board.

The written convening notice may be waived by written consent of each Manager, whether in original, by fax or e-mail

to which an electronic signature (which is valid under Luxembourg law) is affixed.

Any Manager may act at any meeting of the Board by appointing in writing another Manager as his/her/its proxy,

whether in original, by fax or e-mail to which an electronic signature (which is valid under Luxembourg law) is affixed.

Any Manager may participate in a meeting of the Board by conference call, video conference or similar means of

communication whereby (i) all the Managers attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating in the
meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is live and ongoing and (iv) the Managers
can properly deliberate. Participation in a meeting by those means is equivalent to presence in person at such meeting.

The Board can validly deliberate and make decisions only if at least the majority of its members are present and/or

represented. A Manager may represent more than one of his/her/its colleagues, provided however that at least two (2)
Managers are present at the meeting, including via means of communication permitted under these Articles and the
Company Law. Decisions are made by the majority of the Managers present and/or represented.

In case of a tied vote, the Chairman of the meeting shall have a casting vote.
Notwithstanding  the  above,  resolution(s)  of  the  Board  may,  in  emergency  situations  or  where  other  exceptional

circumstances so require, be passed in writing. Such written resolution(s) shall consist of one (1) or more documents
containing the resolution(s) signed by each Manager, and to which a manual or electronic signature (which is valid under
Luxembourg law) is affixed. The date of the resolution(s) will be the date of the last signature.

Article 14 does not apply in case the Company is managed by a Sole Manager.

Art. 15. Minutes of meetings of the board or minutes of resolutions of the sole manager. Resolutions passed by the

Sole Manager shall be documented in written minutes signed by him/her/it and kept at the Company's registered office.

For any meeting of the Board, minutes shall be signed either by the Chairman, the member of the Board who chaired

the meeting, or by all the Managers present at the meeting.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the

Chairman, any Manager or, as the case may be, the Sole Manager.

Art. 16. Powers of the board/sole manager. The Board or, as the case may be, the Sole Manager is vested with the

broadest powers to manage the business of the Company and to authorize and/or perform or cause to be performed all
acts of disposal and administration falling within the corporate objects of the Company.

All powers which are not expressly reserved to the General Meeting by the Company Law or by these Articles fall

within the competence of the Board or, as the case may be, of the Sole Manager.

120224

L

U X E M B O U R G

Art. 17. Delegation of powers. The Board may appoint a person (délégué à la gestion journalière), who need not be

a Shareholder or a Manager, and who shall have full authority to act on behalf of the Company in all matters connected
to its daily management and affairs.

The Board may appoint a person, who need not be a Shareholder and/or a Manager, as permanent representative of

a Luxembourg public limited liability company (société anonyme) or of any other entity when required by its local law.
In the case of a Sole Manager, the Sole Manager may appoint a person, who need not be a Shareholder, as permanent
representative of a Luxembourg public limited liability company (société anonyme) or of any entity when required by its
local law. This permanent representative, whose acts in its capacity as member of the management board of any such
entity will bind the Company, shall act in the name and on behalf of the Company and with all discretion.

The Board or, as the case may be, the Sole Manager, is also authorized to appoint a person, who need not be a Manager,

in order to perform specific functions within the Company.

Art. 18. Binding signatures. The Company shall be bound towards third parties in all matters by (i) the signature of any

two (2) Managers or, as the case may be, (ii) the signature of the Sole Manager.

The Company shall further be bound by the signature or joint signature of any person(s) to whom the Board or, as

the case may be, the Sole Manager has granted specific signatory powers, and only within the limits of those powers. As
the case may be, the Company will be bound by the signature of the person entrusted with its daily management in
accordance with the first paragraph of Article 17 above, and only within the limits of that function.

Art. 19. Liability of the manager(s). The Manager(s) do(es) not assume, by reason of his/her/its/their position, any

personal liability in relation to commitments regularly made by him/her/it/them in the name of the Company provided
such commitments comply with the Articles and the Company Law. They are authorized agents only and are therefore
merely responsible for the execution of their mandate.

Art. 20. Audit. If the number of Shareholders exceeds twenty-five (25), the operations of the Company shall be su-

pervised by one (1) or more statutory auditor(s) (commissaire(s) aux comptes), or, where required by the Company
Law, an independent external auditor (réviseur d'entreprises agréé).

The General Meeting shall appoint the statutory auditor(s) (commissaire(s) aux comptes), if any and the independent

external auditor (réviseur d'entreprises agréé), if any, and determine their number, remuneration and the term of their
office, which may not exceed six (6) years. The statutory auditor(s) (commissaire(s) aux comptes) and the independent
external auditor (réviseur d'entreprises agréé) may be re-appointed.

Art. 21. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on the first (1 

st

 ) day of April of each year

and ends on the thirty-first (31 

st

 ) day of March of the following year.

Art. 22. Annual accounts. The Board or, as the case may be, the Sole Manager draws up at the end of every accounting

year, the annual accounts of the Company and an inventory in the form required by the Company Law.

Each Shareholder may inspect the above inventory and annual accounts at the Company's registered office.

Art. 23. Allocation of profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the

legal reserve in accordance with the Company Law. This allocation ceases to be a requirement as soon as the legal reserve
reaches ten per cent (10%) of the subscribed share capital of the Company as provided in Article 6 of the Articles from
time to time, and becomes compulsory again as soon as the reserve falls below ten per cent (10%).

The Annual General Meeting decides on the allocation of the remaining annual net profits and may, in its own discretion

and within the limits of the Company Law, resolve to pay dividends from time to time, taking into account the corporate
object and policy of the Company.

Interim dividends may be distributed at any time under the following conditions:
(i) the Board or, as the case may be, the Sole Manager draws up interim accounts;
(ii) the interim accounts show that earnings and other reserves (including share premium) are available for distribution,

provided that the amount to be distributed does not exceed profits made since the end of the last financial year for which
annual accounts were approved, if any, plus any profits carried forward and distributable reserves, and minus losses carried
forward and sums to be allocated to the legal reserve;

(iii) the auditor of the Company (if any) has stated in his/her/its report to the Board or, as the case may be, to the

Sole Manager, that conditions (i) and (ii) above have been met;

(iv) the decision to distribute interim dividends is made by the Shareholders, the Board or, where applicable, the Sole

Manager, within two (2) months from the date of the interim accounts;

(v) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company; and
(vi) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the accounting year, the Shareholders

shall be obliged, upon the request of the Company, to refund the excess to it.

Art. 24. Dissolution.  The  Company  is  not  dissolved  by  reason  of  the  death,  suspension  of  civil  rights,  incapacity,

bankruptcy, insolvency or any similar event affecting one (1) or more Shareholders.

120225

L

U X E M B O U R G

The Company may at any time be dissolved by a resolution of the General Meeting adopted in the manner required

for amendment to these Articles, as per Article 12 above. In the event of dissolution of the Company, the liquidation
shall be carried out by one (1) or more liquidators (whether physical or legal persons) appointed by the General Meeting
deciding said liquidation. The General Meeting will also determine the powers and remuneration of the liquidator(s).

The surplus remaining after realization of assets and payment of debts will be distributed to Shareholders in proportion

to the Shares held by them.

Art. 25. Applicable law. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with

the Company Law and subject to any non-waivable provisions of the applicable law, any agreement entered into from
time to time by the Shareholders.”

<i>Transitional provisions

The first accounting year begins on the date hereof and ends on March 31, 2015.

<i>Subscription and payment

The Articles having thus been established, the Founding Shareholder, Queensgate Investments II S.à r.l., represented

as described above, hereby declares that it subscribes to fifteen thousand (15,000) shares representing the total subscribed
share capital of the Company.

All these shares have been fully paid up by the Founding Shareholder by a payment in cash, so that the amount of fifteen

thousand Pound Sterling (GBP 15,000.-) paid by the Founding Shareholder is from now on at the disposal of the Company,
evidence of which has been given to the notary by means of a blocking certificate (certificat de blocage).

<i>Statement - Costs

The notary declares that the conditions prescribed by Articles 182 and 183 of the Company Law have been fulfilled

and expressly bears witness to their fulfillment. Further, the notary executing this deed confirms that these Articles also
comply with the provisions of Articles 27 and 184 of the Company Law.

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed, are estimated at approximately one thousand four hundred Euro (EUR 1,400.-).

The amount of fifteen thousand Pound Sterling (GBP 15,000.-) corresponds to the amount of eighteen thousand seven

hundred and fifty-three Euro and sixty-one Eurocent (EUR 18,753.61).

<i>Resolutions of the sole shareholder

The Founding Shareholder, represented as described above, representing the total subscribed share capital of the

Company, takes the following resolutions:

(a) the number of managers of the Company is set at three (3);
(b) the following persons are appointed as managers of the Company:
- Godfrey Abel, manager, born on July 2, 1960 in Brixworth, United Kingdom, with professional address at 30, rue de

Crecy, L-1364 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

- Joey Wong Thomas, lawyer, born on February 5, 1981 in Kuala Lumpur, Malaysia, with professional address at 22-23

Old Burlington Street, London, W1S 2JJ, United Kingdom; and

- Jaap Meijer, manager, born on September 24, 1965 in Laren, Netherlands, with professional address at 6, Op der

Dresch, L-8127 Bridel, Luxembourg;

(c) the Board members are appointed for an undetermined period; and
(d) the address of the registered office of the Company is set at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand Duchy

of Luxembourg.

The notary, who understands and speaks English, hereby declares that at the request of the Founding Shareholder, the

present deed is worded in English followed by a French version. At the request of said party and in case of discrepancy
between the English and the French versions, the English version shall prevail.

Whereof, the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this deed.
This deed having been read to the proxyholder of the Founding Shareholder, who is known to the notary by his/her

surname, first name, civil status and residence, said proxyholder, together with the notary, signs the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mil quatorze, le vingt du mois de juin,
par-devant nous Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu:

Queensgate Investments LLP, un limited liability partnership constitué selon les lois d'Angleterre et du Pays de Galles,

ayant son siège social 22-23 Old Burlington Street, Londres, W1S 2JJ, Royaume-Uni, immatriculée auprès du Registrar of

120226

L

U X E M B O U R G

Companies for England and Wales sous le numéro OC367000 (l'Associé Fondateur), représenté par Joey Wong Thomas,
agissant en tant que signataire autorisée,

ici représenté par Monsieur Gianpiero SADDI, employé privé, ayant son adresse professionnelle à L-1750 Luxembourg,

74, avenue Victor Hugo, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 19 juin
2014.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de l'Associé Fondateur et par le notaire, restera

annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

Le mandataire de l'Associé Fondateur, a requis le notaire d'enregistrer la constitution d'une société à responsabilité

limitée dont les statuts sont établis comme suit:

«STATUTS

Art. 1 

er

 . Définitions.  À moins que le contexte ne l'indique autrement, les termes suivants auront les significations

suivantes:

Assemblée Générale

signifie l'assemblée générale de(s) (l') Associé(s).

Associés

signifie les personnes inscrites dans le registre des Associés de la Société, conformément
à l'article 185 de la Loi sur les Sociétés, en tant que détenteurs de Parts Sociales de temps
à autre et Associé signifie n'importe lequel d'entre eux.

Associé Unique

signifie la seule personne inscrite dans le registre des Associés de la Société, conformément
à l'article 185 de la Loi sur les Sociétés, en tant que détenteur unique des Parts Sociales de
temps à autre.

Conseil

signifie le conseil de gérance de la Société, si plusieurs Gérants ont été nommés.

Gérants

signifie les personnes nommées en cette qualité par l'Assemblée Générale et Gérant signifie
n'importe lequel d'entre eux.

Gérant Unique

signifie le gérant unique de la Société.

Jour Ouvrable

signifie tout jour (autre qu'un samedi ou un dimanche) durant lequel les banques
commerciales sont normalement ouvertes au public au Grand-Duché de Luxembourg.

Loi AIFM

signifie la loi luxembourgeoise du 12 juillet 2013 transposant la Directive 2011/61/UE du
Parlement Européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les Gestionnaires de Fonds
d'Investissement Alternatifs, telle que modifiée de temps à autre.

Loi sur les Sociétés

signifie la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que
modifiée de temps à autre.

Parts Sociales

signifie les parts sociales nominatives dans le capital social de la Société ayant une valeur
nominale d'une Livre Sterling (GBP 1,-) et Part Sociale signifie n'importe laquelle d'entre
elles.

Président

signifie le président du Conseil de temps à autre.

Résolutions Circulaires
des Associés

prend la signification donnée à ce terme à l'article 11.

Société

signifie Queensgate Investments II S.à r.l.

Statuts

signifie les présents statuts de la Société tels que modifiés au fil du temps.

Art. 2. Forme et dénomination. La dénomination de la Société est «Queensgate Investments II S.à r.l.».
La Société est une société à responsabilité limitée régie par les présents Statuts, la Loi sur les Sociétés et la législation

applicable.

Art. 3. Objet social. L'objet de la Société est d'agir en tant que gestionnaire d'investissement d'un (1) ou plusieurs

fonds d'investissement alternatif, régulés ou pas, établis au Luxembourg ou dans tout autre état membre de l'Union
Européenne, conformément aux dispositions de la Loi AIFM.

La Société peut acquérir, détenir, gérer et disposer de participations ou d'intérêts, tant au Luxembourg qu'à l'étranger,

dans toutes sociétés et/ou entreprises sous quelque forme que ce soit. La Société peut notamment acquérir par sou-
scription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs et instruments financiers
émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle
de toute société et/ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets
ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, excepté par voie d'offre publique, et elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l'émission d'obligations, de billets à ordre, de titres de créance ou de toute
sorte de titres de créance ou de titres participatifs.

La Société peut prêter des fonds comprenant, sans limitation, ceux résultant de ses emprunts et/ou émissions de titres

participatifs ou de titres de créance de toute sorte, à ses filiales, à des sociétés affiliées et/ou à toutes autres sociétés ou
entités qu'elle juge appropriées.

120227

L

U X E M B O U R G

La Société peut également garantir, accorder des sûretés à ou assister de toute autre manière toute société dans

laquelle elle détient une participation directe ou indirecte ou qui fait partie du même groupe de sociétés que la Société.
La Société peut en outre, pour son propre bénéfice et celui de toute autre société ou personne, consentir des garanties,
nantir, céder ou grever de charge ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur tout ou partie de ses actifs
pour garantir ses propres obligations et celles de toute autre société. Pour éviter toute ambiguïté, la Société ne peut pas
exercer d'activités réglementées du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation requise.

La Société peut par ailleurs agir en tant qu'associé commandité ou commanditaire avec responsabilité illimitée ou

limitée pour toutes les dettes et obligations de sociétés en commandite (partnerships) ou entités similaires.

La Société peut employer toutes techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investissements,

y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques liés aux crédits, aux fluctuations des
taux de change, des taux d'intérêt et tout autre type de risques.

La Société peut, pour son propre compte ainsi que pour le compte de tiers, accomplir toutes les opérations et trans-

actions (comprenant, sans limitation, des transactions mobilières et immobilières) utiles ou nécessaires à l'accomplisse-
ment de son objet social ou se rapportant directement ou indirectement à celui-ci.

Art. 4. Durée de la société. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 5. Siège social. Le siège social de la Société est établi dans la commune de Luxembourg. Il peut être transféré vers

toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l'Assemblée Générale statuant de la ma-
nière requise en cas de modification des Statuts, selon l'article 12 ci-dessous. Le siège social peut être transféré par une
résolution du Conseil ou, le cas échéant, par une décision du Gérant Unique, dans les limites de la commune de Luxem-
bourg.

Le Conseil ou, le cas échéant, le Gérant Unique, a également le droit de créer des succursales, des filiales ou d'autres

bureaux en tous lieux qu'il juge appropriés, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Le Conseil ou, le cas échéant, le Gérant Unique peut considérer que des événements extraordinaires d'ordre politique

ou militaire de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre
le siège social de la Société et l'étranger se sont produits ou sont imminents. Dans ce cas, le siège social peut être transféré
temporairement à l'étranger jusqu'à la cessation complète de ces circonstances extraordinaires. Ces mesures temporaires
n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, en dépit du transfert temporaire de son siège social,
restera une société luxembourgeoise.

Art. 6. Capital social. Le capital social souscrit de la Société est fixé à quinze mille Livres Sterling (GBP 15.000,-),

représenté par quinze mille (15.000) Parts Sociales ayant une valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP 1,-).

Le capital social souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution de l'Assemblée Générale

statuant de la manière requise en cas de modification des Statuts, selon l'article 12 ci-dessous.

Art. 7. Parts sociales. Toutes les Parts Sociales sont nominatives, totalement souscrites et entièrement libérées.
Un registre des Associés est tenu au siège social, où il peut être consulté par tout Associé. Ce registre contient le

nom de tout Associé, sa résidence ou son domicile élu, le nombre de Parts Sociales qu'il/elle détient, les montants libérés
pour chacune de ses Parts Sociales, la mention des cessions/souscriptions de Parts Sociales et les dates de ces cessions/
souscriptions ainsi que toutes garanties accordées sur les Parts Sociales de temps à autre. Chaque Associé notifiera son
adresse à la Société par lettre recommandée, ainsi que tout changement d'adresse ultérieur.

La Société peut se baser sur la dernière adresse de l'Associé qu'elle a reçue. La propriété des Parts Sociales est établie

par inscription dans le registre des Associés.

Des certificats constatant ces inscriptions peuvent être émis aux Associés et ces certificats, s'ils sont émis, seront

signés par le Président ou par tout Gérant ou, le cas échéant, par le Gérant Unique.

La Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par Part Sociale. Dans le cas où une Part Sociale serait détenue par

plusieurs personnes, la Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits attachés à cette Part Sociale jusqu'au
moment où une (1) personne aura été désignée comme propriétaire unique vis-à-vis de la Société. La même règle sera
appliquée en cas de conflit entre un usufruitier et un nu-propriétaire ou entre un créancier et un débiteur gagiste.

La Société peut racheter ou retirer ses propres Parts Sociales à condition d'annuler immédiatement les Parts Sociales

rachetées ou retirées et de réduire le capital social souscrit de la Société corrélativement.

Art. 8. Cession de parts sociales. Les Parts Sociales sont librement cessibles entre Associés. À moins que la loi ne le

prévoie autrement, la cession de Parts Sociales à des tiers est soumise à l'accord écrit préalable des Associés représentant
au moins trois-quarts (3/4) du capital social souscrit de la Société. La cession de Parts Sociales à des tiers en raison du
décès d'un Associé doit être approuvée par les Associés représentant trois-quarts (3/4) des droits détenus par les sur-
vivants.

La cession de Parts Sociales peut s'effectuer par une déclaration écrite de la cession inscrite dans le registre des

Associés, cette déclaration de cession devant être datée et signée par le cédant et le cessionnaire, par des personnes
détenant les pouvoirs de représentation nécessaires pour agir à cet effet ou conformément aux dispositions de l'article
1690 du code civil luxembourgeois relatives à la cession de créances.

120228

L

U X E M B O U R G

La Société peut également accepter comme preuve de cession d'autres instruments de cession prouvant le consen-

tement du cédant et du cessionnaire et jugés suffisants par la Société.

Art. 9. Associés. La Société peut avoir un Associé Unique ou des Associés. Si la Société n'a qu'un (1) seul Associé,

toute référence aux Associés dans ces Statuts est une référence à l'Associé Unique et l'Associé Unique détient tous les
pouvoirs conférés à l'Assemblée Générale.

Art. 10. Pouvoirs de l'assemblée générale. Toute Assemblée Générale régulièrement constituée représente tous les

Associés. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, accomplir ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations
de la Société.

Dans ces Statuts, toute référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Assemblée Générale est une

référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Associé Unique aussi longtemps que la Société n'a qu'un (1)
seul Associé. Les décisions prises par l'Associé Unique sont consignées par voie de procès-verbaux écrits.

Art. 11. Assemblée générale annuelle - Autres assemblées générales. Conformément à la Loi sur les Sociétés, si le

nombre des Associés excède vingt-cinq (25), une Assemblée Générale annuelle doit se tenir au siège social de la Société
ou à tout autre endroit de la commune du siège social indiqué dans la convocation de l'Assemblée Générale annuelle.
Elle se tient le deuxième mardi de septembre de chaque année à 14 heures. Si ce jour n'est pas un Jour Ouvrable,
l'Assemblée Générale annuelle se tiendra le premier Jour Ouvrable suivant.

Nonobstant ce qui précède, si le Conseil ou, le cas échéant, le Gérant Unique, considère souverainement que des

circonstances exceptionnelles le requièrent, l'Assemblée Générale annuelle peut se tenir à l'étranger.

Les autres Assemblées Générales sont tenues au lieu et à l'heure spécifiés dans les convocations.
Si  le  nombre  des  Associés  est  inférieur  ou  égal  à  vingt-cinq  (25),  les  résolutions  des  Associés  sont  adoptées  par

l'Assemblée Générale ou par voie de résolutions circulaires(les Résolutions Circulaires des Associés).

Lorsque des résolutions sont adoptées par voie de Résolutions Circulaires des Associés, chaque Associé recevra à

son adresse (telle qu'elle apparaît sur le registre des Associés) le texte des résolutions à passer, qu'il/elle devra signer.
Les Résolutions Circulaires des Associés doivent être signées par tous les Associés pour être valides et engager la Société.
Une fois signées, elles seront valides et engageront la Société de la même manière que si elles avaient été adoptées par
une Assemblée Générale dûment convoquée et tenue et porteront la date de la dernière signature.

Les Résolutions Circulaires des Associés de même que les procès-verbaux des Assemblées Générales sont conservés

au siège social de la Société.

Art. 12. Avis de convocation, Quorum, Procurations et vote. Les Associés sont convoqués aux Assemblées Générales

ou bien consultés par voie de Résolutions Circulaires des Associés à l'initiative (i) de tout Gérant ou, le cas échéant, du
Gérant Unique, (ii) du/des commissaire(s) aux comptes (le cas échéant) ou (iii) d'Associés représentant plus de la moitié
(1/2) du capital social souscrit de la Société.

Sauf en cas d'urgence, dont la nature et les motifs seront mentionnés dans la convocation, les convocations écrites de

toute Assemblée Générale sont envoyées, par lettre recommandée et au moins huit (8) jours calendaires avant la date
de l'Assemblée Générale, à chaque Associé, à son adresse telle qu'elle apparaît sur le registre des Associés tenu par la
Société.

Une Assemblée Générale peut être tenue sans convocation écrite préalable si tous les Associés sont présents et/ou

représentés et se considèrent dûment convoqués et informés de son ordre du jour.

Tout Associé peut prendre part à toute Assemblée Générale en désignant par écrit, soit en original, soit par fax ou

par un courriel muni d'une signature électronique (en conformité avec la loi luxembourgeoise), une autre personne
comme mandataire, Associé ou non.

Tout Associé peut participer à une Assemblée Générale par conférence téléphonique, vidéo conférence ou tout autre

moyen de communication similaire grâce auquel (i) tous les Associés participant à l'Assemblée Générale peuvent être
identifiés, (ii) toute personne participant à l'Assemblée Générale peut entendre les autres participants et leur parler, (iii)
l'Assemblée Générale est retransmise en direct et en continu et (iv) les Associés peuvent valablement délibérer. La
participation à une Assemblée Générale par un tel moyen de communication équivaudra à une participation en personne
à l'Assemblée Générale.

Les résolutions devant être adoptées en Assemblées Générales sont prises par les Associés représentant plus de la

moitié (1/2) du capital social souscrit de la Société. Si cette majorité n'est pas atteinte lors de la première Assemblée
Générale, les Associés seront convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée Générale et les résolutions
seront  adoptées  lors  de  la  seconde  Assemblée  Générale  à  la  majorité  des  voix  exprimées,  sans  tenir  compte  de  la
proportion du capital social souscrit représenté.

Les présents Statuts peuvent être modifiés avec le consentement d'une majorité en nombre d'Associés représentant

au moins trois-quarts (3/4) du capital social souscrit de la Société.

Le changement de la nationalité de la Société et l'augmentation des engagements des Associés dans la Société exigent

l'accord unanime des Associés.

Chaque Part Sociale donne droit à une (1) voix aux Assemblées Générales.

120229

L

U X E M B O U R G

Art. 13. Gérance. La Société est gérée par un (1) ou plusieurs Gérant(s), Associé(s) ou non. Si plusieurs Gérants sont

nommés, ceux-ci constitueront ensemble le Conseil.

Les Gérants sont nommés par l'Assemblée Générale. L'Assemblée Générale détermine également le nombre de Gé-

rants, leur rémunération et la durée de leur mandat. Un Gérant peut être révoqué avec ou sans motif et/ou remplacé, à
tout moment, par une résolution adoptée par l'Assemblée Générale.

Art. 14. Réunion du conseil. Le Conseil doit nommer un Président parmi ses membres et peut également désigner un

secrétaire.

Le Président préside toutes les réunions du Conseil. En son absence, les autres Gérants présents et/ou représentés

nommeront, par un vote à la majorité simple, un autre Président pro tempore qui présidera la réunion en question.

Le secrétaire, qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil, peut mais ne doit pas être

Gérant.

Les réunions du Conseil sont convoquées par le Président ou par tout Gérant, au lieu indiqué dans la convocation de

la réunion.

Sauf en cas d'urgence, dont la nature et les motifs seront mentionnés dans la convocation, les convocations écrites de

toute réunion du Conseil sont envoyées à chaque Gérant vingt-quatre (24) heures au moins avant la date prévue pour la
réunion.

La réunion peut être tenue sans convocation préalable (i) si tous les Gérants sont présents et/ou représentés et se

considèrent dûment convoqués et informés de son ordre du jour ou (ii) pour une réunion se tenant aux lieu et heure
prévus dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil.

Chaque Gérant peut renoncer à la convocation écrite par un accord écrit soit en original, soit par fax ou par un courriel

muni d'une signature électronique (en conformité avec la loi luxembourgeoise).

Tout Gérant peut participer à une réunion du Conseil en désignant par écrit, soit en original, soit par fax ou par un

courriel muni d'une signature électronique (en conformité avec la loi luxembourgeoise), un autre Gérant comme son
mandataire.

Tout Gérant peut participer à une réunion du Conseil par conférence téléphonique, vidéo conférence ou tout autre

moyen de communication similaire grâce auquel (i) tous les Gérants participant à la réunion peuvent être identifiés, (ii)
toute personne participant à la réunion peut entendre les autres participants et leur parler, (iii) la réunion est retransmise
en direct et en continu et (iv) les Gérants peuvent valablement délibérer. La participation à une réunion par un tel moyen
de communication équivaudra à une participation en personne à la réunion.

Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité au moins de ses membres est présente et/ou

représentée. Un Gérant peut représenter plus d'un de ses collègues, à condition que deux (2) Gérants au moins soient
présents à la réunion ou y participent par un moyen de communication qui est autorisé par les Statuts ou par la Loi sur
les Sociétés. Les décisions sont prises à la majorité des Gérants présents et/ou représentés.

En cas de parité des votes, la voix du Président de la réunion sera prépondérante.
Nonobstant les dispositions qui précèdent, une résolution du Conseil peut également, en cas d'urgence ou de cir-

constances exceptionnelles le justifiant, être adoptée par écrit. Une telle résolution doit consister en un ou plusieurs
documents contenant les résolutions et signés par chaque Gérant, manuellement ou par signature électronique (en con-
formité avec la loi luxembourgeoise). La date de la résolution sera alors la date de la dernière signature.

L'article 14 ne s'applique pas dans le cas où la Société est gérée par un Gérant Unique

Art. 15. Procès-verbaux des réunions du conseil et procès-verbaux des résolutions du gérant unique. Les résolutions

adoptées par le Gérant Unique sont inscrites dans des procès-verbaux signés par elle/lui et tenus au siège social de la
Société.

Pour toute réunion du Conseil, les procès-verbaux des réunions sont signés soit par le Président, soit par le membre

du Conseil qui en aura assumé la présidence, ou encore par tous les Gérants présents à la réunion.

Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs sont signés par le Président, tout

Gérant ou, le cas échéant, le Gérant Unique.

Art. 16. Pouvoirs du conseil/Gerant unique. Le Conseil ou, le cas échéant, le Gérant Unique est investi des pouvoirs

les plus étendus pour gérer les affaires de la Société et autoriser et/ou exécuter ou faire exécuter tous les actes de
disposition et d'administration entrant dans l'objet social de la Société.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi sur les Sociétés ou par ces Statuts à l'Assemblée Générale

sont de la compétence du Conseil ou, le cas échéant, du Gérant Unique.

Art. 17. Délégation de pouvoirs. Le Conseil peut nommer un délégué à la gestion journalière, Associé ou non, Gérant

ou non, et qui aura les pleins pouvoirs pour agir au nom de la Société pour tout ce qui relève de la gestion journalière
et des affaires de la Société.

Le Conseil peut nommer une personne, Associé ou non, Gérant ou non, en qualité de représentant permanent d'une

société anonyme luxembourgeoise ou de toute entité lorsque cela est requis par sa loi locale. En cas de Gérant Unique,
le Gérant Unique peut nommer une personne, Associé ou non, en qualité de représentant permanent d'une société

120230

L

U X E M B O U R G

anonyme luxembourgeoise ou de toute entité lorsque cela est requis par sa loi locale. Ce représentant permanent, dont
les actes en sa qualité de membre du conseil d'administration de cette entité engageront la Société, agira au nom et pour
le compte de la Société.

Le Conseil ou, le cas échéant, le Gérant Unique est aussi autorisé à nommer une personne, Gérant ou non, pour

l'exécution de missions spécifiques dans la Société.

Art. 18. Signatures autorisées. La Société est engagée en toutes circonstances vis-à-vis des tiers par (i) la signature de

deux (2) Gérants ou, le cas échéant, (ii) la signature du Gérant Unique.

La  Société  est  également  engagée  par  la  signature  unique  de  toute  personne  ou  la  signature  conjointe  de  toutes

personnes à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le Conseil ou, le cas échéant, par le Gérant Unique,
et ce dans les limites de ces pouvoirs. Le cas échéant, la Société sera engagée par la seule signature de la personne nommée
délégué à la gestion journalière conformément au premier paragraphe de l'article 17 ci-dessus, et seulement dans les
limites de cette fonction.

Art. 19. Responsabilité du(des) gérant(s). Le(s) Gérant(s), en raison de sa(leurs) fonction(s), ne contracte aucune

obligation personnelle concernant les engagements régulièrement pris par lui/elle au nom de la Société dans la mesure
où ces engagements sont conformes aux Statuts et à la Loi sur les Sociétés. Chaque Gérant n'est qu'un agent autorisé et
n'est donc responsable que de l'exécution de son mandat.

Art. 20. Surveillance. Si le nombre des Associés dépasse vingt-cinq (25), les opérations de la Société seront surveillées

par un (1) ou plusieurs commissaire(s) aux comptes ou, dans les cas prévus par la Loi sur les Sociétés, par un réviseur
d'entreprises agréé.

L'Assemblée Générale nomme le(s) commissaire(s) aux comptes, s'il y a lieu, et le réviseur d'entreprises agréé, s'il y

a lieu, et détermine leur nombre, leur rémunération et la durée de leur fonction pour une période ne pouvant excéder
six (6) ans. Le(s) commissaire(s) aux comptes et le réviseur d'entreprises agréé sont rééligibles.

Art. 21. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le premier (1 

er

 ) avril de chaque année et se termine

le trente et un (31) mars de l'année suivante.

Art. 22. Comptes annuels. Le Conseil ou, le cas échéant, le Gérant Unique, dresse, dans la forme requise par la Loi

sur les Sociétés, les comptes annuels de la Société et un inventaire à la fin de chaque exercice social.

Chaque Associé peut inspecter l'inventaire et les comptes annuels au siège social de la Société.

Art. 23. Affectation des bénéfices. Il est prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent (5%) qui sont

affectés à la réserve légale requise par la Loi sur les Sociétés. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve
légale atteint dix pour cent (10%) du capital social souscrit de la Société tel qu'il est fixé à l'article 6 des Statuts de temps
à autre et devient à nouveau obligatoire si la réserve légale descend en dessous de ce seuil de dix pour cent (10%).

L'Assemblée Générale Annuelle décide de l'affectation du solde du bénéfice net annuel et peut, dans les limites de la

Loi sur les Sociétés, décider de manière discrétionnaire de payer des dividendes de temps à autre, en prenant en compte
l'objet et la politique de la Société.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment dans les conditions suivantes:
(i) le Conseil ou, le cas échéant, le Gérant Unique, dresse des comptes intérimaires;
(ii) les comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves (y compris les primes d'émission) sont

disponibles pour une distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis
la fin de la dernière année pour laquelle des comptes annuels ont été approuvés (le cas échéant), augmenté des bénéfices
reportés et des réserves distribuables, et réduit des pertes reportées et des sommes à allouer à la réserve légale;

(iii) le commissaire aux comptes de la Société, le cas échéant, a constaté dans son rapport au Conseil ou, le cas échéant,

au Gérant Unique, que les conditions (i) et (ii) ci-dessus ont été satisfaites;

(iv) la décision de distribuer des acomptes sur dividendes est prise par les Associés, le Conseil ou, le cas échéant, le

Gérant Unique, dans les deux (2) mois suivant la date des comptes intérimaires;

(v) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société; et
(vi) lorsque les acomptes sur dividendes distribués dépassent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social, les

Associés doivent, sur demande de celle-ci, en rembourser l'excédent à la Société.

Art. 24. Dissolution. La Société n'est pas dissoute du fait du décès, de la suspension des droits civils, de l'incapacité,

de la faillite, de l'insolvabilité ou de tout autre évènement similaire affectant un (1) ou plusieurs Associés.

La Société peut être dissoute à tout moment par une résolution de l'Assemblée Générale statuant de la manière requise

en cas de modification des Statuts, selon l'article 12 ci-dessus. En cas de dissolution de la Société, la liquidation est effectuée
par un ou plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'Assemblée Générale
décidant cette liquidation. Cette Assemblée Générale déterminera également les pouvoirs et la rémunération du ou des
liquidateur(s).

Le boni de liquidation sera, après la réalisation des actifs et le paiement des dettes, distribué aux Associés propor-

tionnellement aux Parts Sociales qu'ils détiennent.

120231

L

U X E M B O U R G

Art. 25. Droit applicable. Toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les présents Statuts seront

tranchées conformément à la Loi sur les Sociétés et, sous réserve des dispositions légales d'ordre public, à tout accord
conclu de temps à autre par les Associés.»

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence à la date du présent acte et se termine le 31 mars 2015.

<i>Souscription et libération

Les Statuts ayant ainsi été arrêtés, l'Associé Fondateur, Queensgate Investments LLP, représenté tel que décrit ci-

dessus, déclare souscrire à quinze mille (15.000) parts sociales représentant la totalité du capital social souscrit de la
Société.

Toutes ces parts sociales ont été entièrement libérées par l'Associé Fondateur par un paiement en numéraire, de sorte

que le montant de quinze mille Livres Sterling (GBP 15.000,-) est désormais à la disposition de la Société, ainsi qu'il a été
prouvé au notaire par le biais d'un certificat de blocage.

<i>Déclaration - Estimation des frais

Le notaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées aux articles 182 et 183 de la Loi sur les Sociétés

et en constate expressément l'accomplissement. Il confirme en outre que ces Statuts sont conformes aux dispositions
des articles 27 et 184 de la Loi sur les Sociétés.

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

en raison du présent acte, sont estimés approximativement à la somme de mille quatre cents Euros (EUR 1.400,-).

La somme de quinze mille Livres Sterling (GBP 15.000,-) correspond à la somme de dix-huit mille sept cent cinquante-

trois Euros et soixante et un Eurocent (EUR 18.753,61).

<i>Résolutions de l'associé unique

L'Associé  Fondateur,  représenté  tel  que  décrit  ci-dessus,  représentant  l'intégralité  du  capital  social  souscrit  de  la

Société, a adopté les résolutions suivantes:

(a) le nombre de gérants de la Société est fixé à trois (3);
(b) les personnes suivantes sont nommées en tant que gérants de la Société:
- Godfrey Abel, gérant, né le 2 juillet 1960 à Brixworth, Royaume-Uni, ayant son adresse professionnelle au 30, rue

de Crecy, L-1364 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

- Joey Wong Thomas, juriste, née le 5 février 1981 à Kuala Lumpur, Malaysie, ayant son adresse professionnelle au

22-23 Old Burlington Street, Londres, W1S 2JJ, Royaume-Uni; et

- Jaap Meijer, gérant, né le 24 septembre 1955 à Laren, Pays-Bas, ayant son adresse professionnelle au 6, Op der Dresch,

L-8127 Bridel, Grand-Duché de Luxembourg;

(c) les membres du Conseil sont nommés pour une durée indéterminée; et
(d) l'adresse du siège social de la Société est fixée au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand-Duché de

Luxembourg.

Le notaire qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de l'Associé Fondateur, le présent acte a été établi

en anglais, suivi d'une version française. À la requête de cette même partie et en cas de divergence entre les versions
anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé, même date qu'en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture faite au mandataire de l'Associé Fondateur, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état civil

et demeure, ledit mandataire signe avec le notaire le présent acte.

Signé: G. Saddi et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 30 juin 2014. LAC/2014/29993. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).

<i>Le Receveur (signée): Irène Thill.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juillet 2014.

Référence de publication: 2014106048/662.
(140126007) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2014.

120232

L

U X E M B O U R G

JF Construction S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3490 Dudelange, 11, rue Jean Jaures.

R.C.S. Luxembourg B 188.520.

STATUTS

L'an deux mille quatorze, le vingt-sept juin.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg);

Ont comparu:

1) Madame Ilda JESUS MARQUES ALMEIDA, femme au foyer, née à Pelmá-Alvaiázere (P), le 13 août 1969, demeurant

à L-3441 Dudelange, 3, avenue Grande-Duchesse Charlotte, et

2) Monsieur José Francisco ALVES DE ALMEIDA MARQUES, maçon, né à Cantanhede (P), le 28 décembre 1969,

demeurant à L-3441 Dudelange, 3, avenue Grande-Duchesse Charlotte,

Tous les deux représentés par Monsieur Henri DA CRUZ, employé, demeurant professionnellement à Junglinster, en

vertu d’une procuration donnée sous seing privé.

Laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire et le notaire, restera annexée au présent

acte avec lequel elle sera enregistrée.

Lesquels comparants ont, par leur mandataire, requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts

d'une société à responsabilité limitée qu'ils constituent entre eux:

Titre I 

er

 . - Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1 

er

 .  Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi

que par les présents statuts.

Art. 2. La société à responsabilité limitée prend la dénomination de «JF Construction S.à r.l.».

Art. 3. La société a pour objet tous travaux spécialisés en bâtiment, de fondations (inclut le pieu de fondation), montage

de structures métalliques, préparation des cadres en fer sur le chantier, imperméabilisation et dés humidification des
bâtiments, montage et démontage d’échafaudages et plate-forme de la construction - inclut la location associée à montage,
construction de cheminées et de fours industriels, montage des serres, travaux souterrains, nettoyage de façades à la
vapeur ou de sable, paveur.

La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales et physiques.
Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directe-

ment ou indirectement à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 4. Le siège social est établi dans la Commune de Dudelange.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Art. 5. La durée de la société est illimitée.

Titre II. - Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,-EUR), représenté par cent (100) parts sociales

de cent vingt-cinq euros (125,-EUR) chacune.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article 199 de la

loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 7. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune

d'elles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la société a le droit de suspendre l’exercice des droits afférents,
jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard, propriétaire de la part sociale. Il en sera de
même en cas de conflit opposant l’usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier-gagiste.

Toutefois, les droits de vote attachés aux parts sociales grevées d'usufruit sont exercés par le seul usufruitier.

Art. 8. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmis-

sibles.

En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime

de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer dans les 30

jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.

120233

L

U X E M B O U R G

Le non-exercice du droit de préemption entraîne de plein droit agrément de la proposition de cession initiale.

Art. 9. Le décès, l’interdiction, l’incapacité, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

Titre III. - Administration et gérance

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment

par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement repré-
senter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir la majorité des associés repré-

sentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assemblée

générale sont exercés par l’associé unique.

Les décisions prises par l’associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par

écrit.

De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établies par écrit.

Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

Art. 15. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 16. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 17. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements

et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-

ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

Art. 18. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Titre IV. - Dissolution - Liquidation

Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Titre V. - Dispositions générales

Art. 20. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2014.

<i>Libération de parts sociales

Les statuts ainsi arrêtés, les comparants ont souscrites les parts sociales comme suit:

1.- Monsieur José Francisco ALVES DE ALMEIDA MARQUES, préqualifié, vingt parts sociales . . . . . . . . . . . . .

20

2.- Madame Ilda JESUS MARQUES ALMEIDA, préqualifiée, quatre-vingts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents

euros (12.500,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.

120234

L

U X E M B O U R G

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, est évalué à environ mille cinquante euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt, les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se

sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- L’adresse du siège social est établie à L-3490 Dudelange, 11, rue Jean Jaurès.
2.- L'assemblée désigne comme gérant de la société pour une durée indéterminée:
- Monsieur José Francisco ALVES DE ALMEIDA MARQUES, maçon, né à Cantanhede (P), le 28 décembre 1969,

demeurant à L-3441 Dudelange, 3, avenue Grande-Duchesse Charlotte, gérant technique, et

- Madame Ilda JESUS MARQUES ALMEIDA, femme au foyer, née à Pelmá-Alvaiázere (P), le 13 août 1969, demeurant

à L-3441 Dudelange, 3, avenue Grande-Duchesse Charlotte, gérante administrative t

La société est valablement représentée par la signature seule du gérant technique ou du gérant administrative.

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, connu du notaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Henri DA CRUZ, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 04 juillet 2014. Relation GRE/2014/2679. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2014101255/123.
(140120767) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

PLJ Chelsea, Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 12.000,00.

Siège social: L-8308 Capellen, 89E, Parc d'activités.

R.C.S. Luxembourg B 187.415.

In the year two thousand and fourteen, on the thirteenth day of June,
Before us Maître Joseph ELVINGER civil law notary residing in Luxembourg,Grand Duchy of Luxembourg;

THERE APPEARED:

1) PETERSON (CHELSEA ISLAND) COMPANY LIMITED, incorporated and registered in Hong Kong with company

number  2030162  and  its  registered  office  at  22/F,  South  China  Building,  1-3  Wyndham  Street,  Central,  Hong  Kong
(“PCIL”),

here represented by Flora Gibert, employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given privately;

and

2) DANEHILL CORPORATE LIMITED, incorporated and registered in the British Virgin Islands with company number

1498808 and its registered office at c/o Aleman, Cordero, Galindo &amp; Lee Trust (BVI) Limited, 3 

rd

 Floor, Geneva Place,

Waterfront Drive, PO Box 3175, Road Town, Tortola, British Virgin Islands (“Danehill”),

here represented by Flora Gibert, employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given privately;
The said proxies, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary will remain annexed

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties are the shareholders of PLJ Chelsea, a private limited liability company (société à responsabilité

limitée), incorporated and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having a share capital of twelve
thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), with registered office at 89e, Parc d’Activité, L-8308 Capellen (Mamer), Grand
Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 187415, incor-
porated by deed enacted by Maître Anja Holtz, notary residing in Esch sur Alzette on the twenty-eighth day of May two
thousand and forteen not yet published in the Memorial C. (the "Company").

The appearing parties representing the whole corporate capital and having waived any notice requirement, the general

meeting of shareholders is regularly constituted and may validly deliberate on the following agenda:

<i>Agenda

1. Change of the currency of the share capital of the Company from Euro (EUR) to British Pound Sterling (GBP);
2. Decrease of the nominal value of the shares from twelve Euro fifty cents (EUR 12.50) to one British Pound Sterling

(GBP 1.-);

120235

L

U X E M B O U R G

3. Conversion of the existing one thousand (1,000) shares of the Company having a nominal value of twelve Euro fifty

cents (EUR 12.50) into ten thousand one hundred twenty five (10,125) shares having a nominal value of one British Pound
Sterling (GBP 1.-) so that the share capital of the Company shall henceforth be set at ten thousand one hundred twenty
five British Pound Sterling (GBP 10,125.-);

4. Decrease of the Company’s share capital by an amount of one hundred twenty five British Pounds Sterling (GBP

125.-), by cancellation of one hundred and twenty five (125) shares and allocation of one hundred twenty five British
Pounds Sterling (GBP 125.-) to the share premium account (prime d’émission) of the Company so that the share capital
of the Company shall be set at ten thousand British Pounds Sterling (GBP 10,000.-), represented by ten thousand (10,000)
shares having a par value of one British Pound sterling (GBP 1.-) each;

5. Increase of the Company’s share capitalby an amount of two thousand British Pounds Sterling (GBP 2,000.-) so as

to raise it from its current amount of ten thousand British Pound Sterling (GBP 10,000.-) up to a new amount of twelve
thousand British Pounds Sterling (GBP 12,000.-) by a contribution in cash of an amount of two thousand British Pounds
Sterling (GBP 2,000.-);

6. Restatement of article 5 of the articles of association of the Company that shall now be stated as follows:
“Le capital social est fixé à douze mille Livre sterling (GBP 12,000), divisé en douze mille (12,000) parts sociales d’une

valeur nominale de une Livre sterling (GBP 1,-), réparties comme suit:

1. PETERSON (CHELSEA ISLAND) COMPANY LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,200

2. DANEHILL CORPORATE LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,800

Total des parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,000

Toutes les parts ont été intégralement libérérs par un apport en nature d’une créance, tel qu’il en été justifié par un

apport en nature d’une créance, tel qu’il en a été justifié au notaire instrument, qui le constate expressément.

La propriété des parts sociales résulte des présents statuts ou des acted de cession de parts régulièrement consentis,

sans qu’il y ait lieu à délivrance d’aucun titre.

Chaque part sociale donne driot à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social, ainsi

que des bénéfices.”

7. Miscellaneous.
The Meeting has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

<i>First Resolution

The Meeting resolves to change the currency of the Company’s share capital from Euro (EUR) to British Pound Sterling

(GBP) using the exchange rate quoted on 11 June 2014 by the European Central Bank of eighty-one pence (being zero
point eight one British Pounds Sterling, GBP 0.81) for one euro (EUR 1.-).

<i>Second resolution

The Meeting resolves to decrease the par value of the shares in the share capital of the Company from twelve Euro

fifty cents (EUR 12.50) to one British Pound sterling (GBP 1,-).

<i>Third resolution

The Meeting resolves to convert the existing one thousand (1,000) shares of the Company having a par value of twelve

Euro fifty cents (EUR 12.50) into ten thousand one hundered twenty five (10,125) shares having a par value of one British
Pound (GBP 1.-) using the above-mentioned exchange rate so that the share capital of the Company shall henceforth be
set at ten thousand one hundered twenty five British Pound Sterling (GBP 10,125.-).

<i>Fourth resolution

The Meeting resolves to decrease the Company’s share capital by an amount of one hundred twenty five British Pounds

Sterling (GBP 125), by cancellation of one hundred and twenty five (125) shares and allocation of one hundred twenty
five British Pounds Sterling (GBP 125) to the share premium account (prime d’émission) of the Company so that the
share capital of the Company shall be set at ten thousand British Pounds Sterling (GBP 10,000.-), represented by ten
thousand (10,000) shares having a par value of one British Pound sterling (GBP 1.-) each.

<i>Fifth resolution

The Meeting further resolves to increase the Company’s share capital by an amount of two thousand British Pound

Sterling (GBP 2,000), in order to bring it from its current amount of ten thousand British Pound Sterling (GBP 10,000)
up to a new amount of twelve thousand British Pound Sterling (GBP 12,000) through the issuance of two thousand (2,000)
new shares with a par value of one British Pound Sterling (GBP 1,-) each.

<i>Subscription - Payment

All two thousand (2,000) new shares with a par value of one British Pound Sterling (GBP 1.-) each have been pro rata

subscribed for by PETERSON (CHELSEA ISLAND) COMPANY LIMITED (“PCIL”)in the amount of one thousand two
hundered (1,200) shares and by DANEHILL CORPORATE LIMITED (“Danehill”) in the amount of eight hundered (800)

120236

L

U X E M B O U R G

shares and have been fully paid up in cash by way of a contribution in cash of an amount of two thousand British Pound
Sterling (GBP 2,000) in the amount of one thousand two hundered British Pound Sterling (GBP 1,200.-) by PCIL and eight
hundered British Pound Sterling (GBP 800.-) by Danehill both to be allocated to the share capital account of the Company,
so that the total amount of two thousand British Pound Sterling (GBP 2,000) is as of now at the disposal of the Company,
as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Sixth resolution

The Meeting resolves to restate article 5 of the articles of association of the Company that shall now be read as follows:
“Le capital social est fixé à douze mille Livre sterling (GBP 12.000,-), divisé en douze mille (12.000) parts sociales d’une

valeur nominale de une Livre sterling (GBP 1,-)chacune, réparties comme suit:

1. PETERSON (CHELSEA ISLAND) COMPANY LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.200

2. DANEHILL CORPORATE LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.800

Total des parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.000

La propriété des parts sociales résulte des présents statuts ou des actes de cession de parts régulièrement consentis,

sans qu’il y ait lieu à délivrance d’aucun titre.

Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social, ainsi

que des bénéfices.”

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at one thousand three hundred euro (EUR 1,300.-).

There being no further business, the meeting is closed.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first written above.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read to the proxy holder of the appearing persons, who is known to the undersigned

notary by his surname, first name, civil status and residence, he signed together with the undersigned notary, this original
deed.

Follows the french translation

L’an deux mille quatorze, le treize juin.
Par-devant nous Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

ONT COMPARU:

1) PETERSON (CHELSEA ISLAND) COMPANY LIMITED, dûment établie à Hong Kong sous le numéro 2030162 et

ayant son siège social au 22/F, South China Building, 1-3 Wyndham Street, Central, Hong Kong (“PCIL”), Représenté par
Flora Gibert, clerc de notaire résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée sous seing
privé; et

2) DANEHILL CORPORATE LIMITED, dûment établie aux Iles Vierges Britanniques sous le numéro 1498808 et ayant

son siège social au c/o Aleman, Cordero, Galindo &amp; Lee Trust (BVI) Limited, 3 

rd

 Floor, Geneva Place, Waterfront Drive,

PO Box 3175, Road Town, Tortola, British Virgin Islands (“Danehill”),

Représenté par Flora Gibert, clerc de notaire résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une procuration

donnée sous seing privé.

Lesdites procurations, paraphées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire resteront anne-

xées au présent acte afin d’être soumises en même temps aux autorités d’enregistrement.

Lesdites parties comparantes sont les associés de PLJ Chelsea, une société à responsabilité limitée (a private limited

liability company), constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de douze
mille cinq cent Euros (EUR 12,500.-), ayant son siège social au 89e, Parc d’Activité, L-8308 Capellen (Mamer), Grand-
Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
187415, constituée par acte authentique non publié au Mémorial C par Maître Anja Holtz, notaire résidant à Esch sur
Alzette le 28 mai 2014 (la "Société").

Les parties comparantes représentant l’intégralité du capital social et ayant renoncé aux formalités de convocation,

l’assemblée générale des associés est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Orde du jour

1. Changement de la devise du capital social de la Société de l’Euro (EUR) à la Livre sterling (GBP);
2. Diminution de la valeur nominale des parts sociales passant de douze Euros et cinquante centimes (EUR 12,50) à

une Livre sterling (GBP 1,-);

120237

L

U X E M B O U R G

3. Conversion des mille (1.000) parts sociales existantes de la Société ayant une valeur nominale de douze Euros et

cinquante centimes (EUR 12,50) en dix mille cent vingt-cinq (10.125) parts sociales ayant une valeur nominale d’une Livre
sterling (GBP 1,-) afin que le Capital Social de la Société soit désormais fixé à dix mille cent vingt-cinq Livres sterling (GBP
10.125,-);

4. Diminution du Capital Social de la Société d’un montant de cent vingt-cinq Livres sterling (GBP 125,-), par l’annulation

de cent vingt-cinq (125) parts sociales et allocation de cent vingt-cinq Livres sterling (GBP 125,-) à la prime d’émission
de la Société afin que la Capital Social de la Société soit fixé à dix mille Livres sterling (GBP 10.000,-), représenté par dix
mille (10.000) parts sociales ayant une valeur nominale de une Livre sterling (GBP 1,-) chacune;

5. Augmentation du Capital Social de la Société à concurrence d’un montant de deux milles Livres sterling (GBP 2.000,-)

afin de le porter de son montant actuel de dix mille Livres sterling (GBP 10.000,-) à un nouveau montant de douze mille
Livres sterling (GBP 12.000,-), par un apport en numéraire d’un montant de deux mille Livres sterling (GBP 2.000,-);

6. Modification de l’article 5 des statuts de la Société qui doit dorénavant avoir la teneur suivante:
“Le capital social est fixé à douze mille Livre sterling (GBP 12.000,-), divisé en douze mille (12.000) parts sociales d’une

valeur nominale de une Livre sterling (GBP 1,-) chacune, réparties comme suit:

1. PETERSON (CHELSEA ISLAND) COMPANY LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.200

2. DANEHILL CORPORATE LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.800

Total des parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.000

La propriété des parts sociales résulte des présents statuts ou des actes de cession de parts régulièrement consentis,

sans qu’il y ait lieu à délivrance d’aucun titre.

Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social, ainsi

que des bénéfices.”

7. Divers.
L’Assemblée a requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivantes:

<i>Première Résolution

L’Assemblée décide de changer la devise du Capital Social de la Société de l’Euro (EUR) à la Livre sterling (GBP) en se

basant sur le taux de change fixé par la Banque Centrale Européenne le 11 juin 2014 de quatre-vingt et un centimes (soit
zéro virgule quatre-vingt et une Livre sterling (GBP 0,81) pour un Euro (EUR 1,-).

<i>Seconde résolution

L’Assemblée décide de diminuer la valeur nominale des parts du Capital Social de la Société de douze Euros et cinquante

centimes (EUR 12,50) à une Livre sterling (GBP 1.-).

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide de convertir les mille (1.000) parts sociales existantes de la Société ayant une valeur nominale de

douze Euros et cinquante centimes (EUR 12,50) en dix mille cent vingt-cinq (10.125) parts sociales ayant une valeur
nominale de une Livre sterling (GBP 1,-) en se basant sur le taux de change cité ci-dessus afin que le Capital Social de la
Société soit désormais fixé à dix mille cent vingt-cinq Livres sterling (GBP 10.125,-).

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide de diminuer le Capital Social de la Société du montant de cent vingt-cinq Livres sterling (GBP

125,-), par l’annulation de cent vingt-cinq (125) parts sociales et le versement de cent vingt-cinq Livres sterling (GBP 125,-)
à la prime d’émission de la Société, afin que le Capital Social de la Société soit fixé à dix mille Livres sterling (GBP 10.000,-),
représenté par dix mille (10.000) parts sociales ayant une valeur nominale d’une Livre sterling (GBP 1,-) chacune.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée décide ensuite d’augmenter le Capital Social de la Société d’un montant de deux mille Livres sterling (GBP

2.000,-), afin de le porter de son montant actuel de dix mille Livres sterling (GBP 10.000,-) à un nouveau montant de
douze mille Livres sterling (GBP 12.000,-) par l’émission de deux mille (2.000) nouvelles parts sociales ayant une valeur
nominale d’une Livre sterling (GBP 1,-) chacune.

<i>Souscription - Paiement

Les deux mille (2.000) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale d’une Livre sterling (GBP 1,-) chacune ont

été souscrites au prorata par PETERSON (CHELSEA ISLAND) COMPANY LIMITED («PCIL») à la hauteur de mille deux
cents (1.200) parts sociales et par DANEHILL CORPORATE LIMITED («Danehill») à la hauteur de huit cents (800) parts
sociales et ont été intégralement payées en numéraires par le biais d’un apport en numéraire d’un montant de deux mille
Livres sterling (GBP 2.000,-) à la hauteur de mille deux cents Livres sterling (GBP 1.200,-) par PCIL et de huit cents Livres
sterling (GBP 800) par Danehill, alloués au Capital Social de la Société, afin que le montant total de deux mille Livres
Sterling soit désormais à la disposition de la Société, tel qu’il en a été justifié au notaire soussigné.

120238

L

U X E M B O U R G

<i>Sixième résolution

L’Assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts de la Société qui doit dorénavant avoir la teneur suivante:
“Le capital social est fixé à douze mille Livre sterling (GBP 12.000,-), divisé en douze mille (12.000) parts sociales d’une

valeur nominale de une Livre sterling (GBP 1,-), réparties comme suit:

1. PETERSON (CHELSEA ISLAND) COMPANY LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.200

2. DANEHILL CORPORATE LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.600

Total des parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.000

La propriété des parts sociales résulte des présents statuts ou des actes de cession de parts régulièrement consentis,

sans qu’il y ait lieu à délivrance d’aucun titre.

Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social, ainsi

que des bénéfices.”

<i>Frais

Les frais, coûts, rémunérations et charges de quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à

sa charge à raison du présent acte sont évalués à mille trois cents euros (EUR 1.300,-).

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Le présent acte notarié est passé à Luxembourg, à la date mentionnée au début de ce document.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue anglaise, suivi d’une traduction en français. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, connu du notaire soussigné par

ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec, le notaire soussigné, le présent acte.

Signé: F. GIBERT, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils le 18 juin 2014. Relation: LAC/2014/28262. Reçu soixante quinze euros (EUR

75,-).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

Référence de publication: 2014106031/220.
(140126840) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2014.

CEREP GAB S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 12.000,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 139.086.

Les comptes annuels au 30 juin 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juin 2014.

Référence de publication: 2014100896/10.
(140120862) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

Diapason Gestion S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg B 114.892.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 25 juin 2014

Après délibération, l'assemblée générale prend, à l'unanimité les résolutions suivantes:
L'assemblée réélit à l'unanimité GABEDELEM S.A., Compagnie Luxembourgeoise d'Investissements et de Conseils

(C.L.I.C.) S.A., Madame Rouxel Annick, Monsieur Majerus Georges et Monsieur Pelletier Sylvain jusqu'à l'assemblée gé-
nérale qui se tiendra en l'année 2020.

L'assemblée générale décide de réélire la société Société de gestion internationale S. à r. l., ayant son siège social à L

- 4761 Pétange, 59, route de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B,
sous le n° B 077 606, comme commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2020.

Luxembourg, le 25 juin 2014.

Référence de publication: 2014100939/16.
(140121099) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

120239

L

U X E M B O U R G

Emo - Produits de Viande - Differdange, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4670 Differdange, 5, rue de Soleuvre.

R.C.S. Luxembourg B 13.286.

DISSOLUTION

L'an deux mille quatorze, le quatre juillet.
Pardevant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

A comparu:

- Madame Amandine BOLER veuve PROMME, retraitée, demeurant à L-4518 Differdange, 46, rue Xavier Brasseur,
ici représentée par Madame Josée PROMME, retraitée, demeurant à L-4580 Differdange, 37, rue de Hussigny, en vertu

d'une procuration donnée sous seing privé en date du 19 mars 2014.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant,

annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

- Monsieur Nico EISCHEN, retraité, demeurant à L-5630 Mondorf-les-Bains, 2, Avenue du Dr Klein.
Les comparants exposent ce qui suit:
1) Par suite du décès de l’associé Monsieur Ferdinand PROMME, survenu le 2 janvier 2010, les parts sociales détenues

par lui dans la société, soit quarante (40) parts sociales, ont été intégralement attribuées à son conjoint survivant Madame
Amandine BOLER, susdite, ainsi qu'il résulte de la déclaration de succession déposée le 18 janvier 2010 par suite de son
décès.

2) Ils sont propriétaire de la totalité des parts sociales de la société dénommée "EMO - PRODUITS DE VIANDE -

DIFFERDANGE", une société à responsabilité limitée établie et ayant son siège social à L-4670 Differdange, 5, rue de
Soleuvre, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B13.286, constituée suivant acte du notaire
du notaire Joseph KERSCHEN de Differdange en date du 20 juin 1975, non publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, et dont le capital social est fixé à cent mille Francs Luxembourgeois (LUF 100.000,-) soit la somme de
deux mille quatre cent soixante-dix-huit euros quatre-vingt quatorze cents (EUR 2.478,94), représenté par cent (100)
parts sociales d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, entièrement libérées.

2) L'activité de la Société a cessé.
3) Siégeant en assemblée générale extraordinaire modificative des statuts de la Société, ils prononcent la dissolution

anticipée de la Société avec effet immédiat.

4) Ils désignent Monsieur Nico EISCHEN comme liquidateur de la Société, et Monsieur EISCHEN, en cette qualité,

requiert le notaire d'acter que tout le passif de la Société est réglé tandis que le passif en relation avec la clôture de la
liquidation est dûment approvisionné et qu'enfin, par rapport à d'éventuels passifs de la Société actuellement inconnus et
donc non encore payés, ils assument irrévocablement l’obligation de les payer de sorte que tout le passif de la Société
est réglé.

5) L'actif restant est attribué aux associés au prorata de leur participation dans la société.
6) La liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.
7) Décharge pleine et entière est donnée aux gérants de la Société.
8) Les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq (5) ans à l’ancien siège social.
9) Déclaration que, conformément à la loi du 12 novembre 2004, les associés actuels sont les bénéficiaires économiques

de l’opération.

Pour les publications et dépôts à faire, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: PROMME, EISCHEN, ARRENSDORFF.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 4 juillet 2014. Relation: LAC / 2014 / 31180. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Luxembourg, le 21 juillet 2014.

Référence de publication: 2014106575/52.
(140127472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2014.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

120240


Document Outline

Alce Investment I S.à r.l.

Alcove Europe Two S.à r.l.

Apollo 11 S.à r.l.

Aramis International 1 S.à r.l.

Ben Zion S.à r.l.

Bepaumat Sàrl

Berwand S.A.

Berwand S.A.

BOP Properties S.A.

Bords de Seine 1 Lux S.à r.l.

Braga Holding

Bucobi S.à r.l.

Büko Immobilien S.A.

Business Pollination S.A.

Callassou International S.à r.l.

Camping-Concept Sàrl

Campria Capital S.A. S.P.F.

Carcenter S.àr.l.

Casada Holding S.A.

Casinvest Iena S.à r.l.

Castello Borghese S.à r.l.

Centralis Immobilière S.à r.l.

CEP D'or S.A.

CEP III Investments S.C.A.

CEREP GAB S.à r.l.

Chemtech

Chemtrade Luxembourg S.à r.l.

CS Investment Funds 2

CVC Investments Vista II S.C.A.

Diapason Gestion S.A.

Digital Services XXXII (GP) S.à r.l

Emo - Produits de Viande - Differdange

Epajona S.àr.l.

Floral S.A.

G.A.T.S. Invest S.A.

Gerona Holdings S.à r.l.

Getinge Holding Luxembourg S.à r.l.

Interminerals S.A.

JF Construction S.à r.l.

Larry Berlin I S.à r.l.

Larry II Potsdam S.à r.l.

Longeville S.A. SPF

Lux 39 Starlight GBP S.à r.l.

Luxury Fashion Luxembourg S.A.

Madera S.à r.l.

Maine Consulting S.A.

MDC Holdco S.à r.l.

Milort S.A.

Morgan Stanley Equity Derivative Services (Luxembourg) S.à r.l.

Multipharma S.A.

PLJ Chelsea

Queensgate Investments II s.à R.L.

SCPack Holdings Management S.à r.l &amp; Partners S.C.A.

SJ Properties Aubervilliers DebtCo Lux S.C.A.

Stibbe Luxembourg Sàrl

Store Invest S.A.

Sud Petrol S.A.

Tiareno Trade S.A.