logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2432

10 septembre 2014

SOMMAIRE

AFP (Germany) IV S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

116695

Aida Wedo 10 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116694

Alarane S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116694

Aristotle S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116722

Compagnie Financière de Participations

Européennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116735

Corpus Sireo Investment Residential No.

14 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116733

Digital Services XXV (GP) S.à r.l.  . . . . . . .

116704

DRC2 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116715

EEE 3 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116697

EEE 5 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116698

Eltis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116690

EPP Bois Chaland (Lux) S.à r.l.  . . . . . . . . . .

116690

EPP Dames de Paris (Lux) S.à r.l. . . . . . . . .

116691

EPP Massy Ile de France (Lux) S.à r.l.  . . . .

116691

EPS Participations S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

116692

EQUI Specialized Asset Management S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116692

Eulerphi S.C.A. SICAF-SIF  . . . . . . . . . . . . . .

116690

Eurofin Capital SICAV - SIF SCA  . . . . . . . .

116691

Euro Immobiltecno Invest S.A.  . . . . . . . . . .

116693

Euro Leasing AG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116694

Europa Rock S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116697

European Dynamics Luxembourg S.A.  . . .

116693

European NPL S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116698

Euroshoes S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116694

Eurosoft Project S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116695

EVPA Group S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116695

Exclusive Real Estate S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

116694

Executive Job S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116695

Fabe S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116690

Face International S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

116698

Federal Express Luxembourg, Inc.  . . . . . . .

116690

Fertifin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116691

FFS 2 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116692

FFS 3 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116693

FIDEURO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116698

Finbra S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116699

Flex S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116696

Flex S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116700

Flint Hills Resources Financing S.à r.l. . . . .

116734

Flovax  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116691

FN International  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116692

Foncière de Seine S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116697

Foncier & Participations S.A. . . . . . . . . . . . .

116696

Forum TFI Investment S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

116699

Franchise International (Luxembourg)  . . .

116699

FR Group Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

116692

Froidchapelle S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116700

Fundamentum Asset Management S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116693

Fundo de Investimento Privado - Angola

S.C.A., SICAV-SIF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116700

Funds For Good S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116693

General Shale Finance S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

116734

G-Finance S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116700

Globec Industries  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116699

G-P Latin America S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

116730

Iberian Capital III  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116736

KKR International Flowers S.à r.l.  . . . . . . .

116696

Monitchem Holdco 2 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

116701

Presco Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

116730

Tilia Investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116718

116689

L

U X E M B O U R G

Eltis, Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 46.635.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014095806/10.
(140114705) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2014.

EPP Bois Chaland (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 65.865.

Les comptes annuels au 30 Novembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014095809/10.
(140114364) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2014.

Fabe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 175.297.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Fabe S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S. à r.l.

Référence de publication: 2014095833/11.
(140114246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2014.

Federal Express Luxembourg, Inc., Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-8378 Kleinbettingen, 1, rue du Chemin de Fer.

R.C.S. Luxembourg B 27.511.

Les comptes annuels de la maison mère au 31 mai 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014095854/11.
(140113599) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2014.

Eulerphi S.C.A. SICAF-SIF, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 159.992.

Société anonyme fondée le 25 Mars 2011 et publication dans le Mémorial C-N° 1513 du 8 juillet 2011.

Les comptes annuels de 2013 ont été clôturés au 31 Décembre 2013 et approuvés lors de l’assemblée ordinaire des

actionnaires le 12 juin 2014 au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Finexis S.A.

Référence de publication: 2014095819/12.
(140113929) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2014.

116690

L

U X E M B O U R G

EPP Dames de Paris (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 105.382.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014095810/10.
(140114356) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2014.

EPP Massy Ile de France (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 105.385.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014095811/10.
(140114365) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2014.

Fertifin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 22, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 123.377.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour FERTIFIN S.A.
Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2014095856/11.
(140114737) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2014.

Flovax, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9647 Doncols, 24, Bohey.

R.C.S. Luxembourg B 163.616.

<i>Extrait du procès-verbal des résolutions prises par les associés en date du 13 juin 2014 au siège social de la société.

Les associés adoptent la résolution suivante:
De transférer le siège social avec effet au 10 juin 2014 au numéro 24 Bohey, L-9647 Doncols

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2014095873/11.
(140113543) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2014.

Eurofin Capital SICAV - SIF SCA, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds

d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6A, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 167.668.

Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg après approbation

à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires en date du 20 juin 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 Juillet 2013.

Référence de publication: 2014095822/12.
(140114842) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2014.

116691

L

U X E M B O U R G

EPS Participations S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 488, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 182.249.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 juillet 2014.

Référence de publication: 2014095813/10.
(140114141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2014.

EQUI Specialized Asset Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2611 Luxembourg, 51, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 149.923.

Les comptes annuels audités au 31/12/2013 de la société EQUI Specialized Asset Management S.A, Société Anonyme,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014095814/10.
(140114466) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2014.

FN International, Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 10.380.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour FN INTERNATIONAL
Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2014095874/11.
(140114052) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2014.

FR Group Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 170.433.

Les statuts coordonnés au 25 juin 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Marc Loesch
<i>Notaire

Référence de publication: 2014095878/11.
(140113998) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2014.

FFS 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 154.817.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 juillet 2014.

Carsten SÖNS
<i>Mandataire

Référence de publication: 2014095857/12.
(140114242) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2014.

116692

L

U X E M B O U R G

Euro Immobiltecno Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 52.033.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014095820/10.
(140113957) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2014.

European Dynamics Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

R.C.S. Luxembourg B 64.911.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014095826/10.
(140113976) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2014.

Fundamentum Asset Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 63.825.

Le bilan de la Société au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juillet 2013.

<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014095884/11.
(140114294) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2014.

Funds For Good S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1630 Luxembourg, 56, rue Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 156.449.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 30 juin 2014.

Pour statuts coordonnés

Référence de publication: 2014095885/11.
(140114631) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2014.

FFS 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 165.666.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 juillet 2014.

Carsten SÖNS
<i>Mandataire

Référence de publication: 2014095858/12.
(140114174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2014.

116693

L

U X E M B O U R G

Euro Leasing AG, Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 102.598.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014095821/9.
(140114416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2014.

Euroshoes S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9050 Ettelbruck, 46, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 99.717.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014095827/10.
(140114545) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2014.

Exclusive Real Estate S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 59.430.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014095831/10.
(140114355) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2014.

Aida Wedo 10 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 8, place Winston Churchill.

R.C.S. Luxembourg B 185.358.

<i>Extrait de l'Assemblée Générale annuelle des Actionnaires qui s'est tenue le 3 juillet 2014

Monsieur Alexis Bourbon a démissionné de son poste d'administrateur de catégorie B.
Madame Céline Doyen, née à Huy (Belgique) le 24 juin 1972, résidant au 8 place Winston Churchill L-1340 Luxembourg,

a été nommée au poste d'administrateur de catégorie B jusqu'à la prochaine Assemblée Générale qui aura lieu en 2017.

Luxembourg, le 3 juillet 2014.

Référence de publication: 2014099626/12.
(140119074) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2014.

Alarane S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 93.145.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2014099633/13.
(140118612) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2014.

116694

L

U X E M B O U R G

EVPA Group S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 135.495.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014095830/9.
(140114872) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2014.

Eurosoft Project S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 108.642.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014095828/10.
(140114366) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2014.

Executive Job S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6143 Junglinster, 20, rue Jean-Pierre Ries.

R.C.S. Luxembourg B 84.968.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juillet 2014.

Signature.

Référence de publication: 2014095832/10.
(140114120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2014.

AFP (Germany) IV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 172.964.

EXTRAIT

Il résulte d'une décision prise par l'associé unique de la Société en date du 03 juillet 2014 que:
- La démission de Mesdames Anne Delord et Priscille Fourneaux de leurs fonctions de gérantes de la Société a été

acceptée avec effet au 3 juillet 2014.

- Monsieur Peter Dickinson, né le 1 

er

 mars 1966 à Nuneaton, Royaume-Uni, avec adresse professionnelle au 51,

Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, a été nommé gérant de la Société avec effet au 03 juillet 2014, pour une
durée indéterminée.

- Madame Alexandra Fantuz, née le 25 septembre 1974 à Hayange, France, avec adresse professionnelle au 51, Avenue

John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, a été nommée gérante de la Société avec effet au 03 juillet 2014, pour une durée
indéterminée.

- Monsieur Ian Richard Gear, né le 25 décembre 1974 à Chelmsford, Royaume-Uni avec adresse professionnelle au 1

Knightsbridge, 3 

rd

 Floor, London SW1X 7LX, Royaume-Uni, a été nommé gérant de la Société avec effet au 03 juillet

2014, pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 09 juillet 2014.

Pour extrait sincère et conforme
Sanne Group (Luxembourg) S.A

Référence de publication: 2014099624/25.
(140118934) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2014.

116695

L

U X E M B O U R G

Flex S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8362 Grass, 6, rue des Champs.

R.C.S. Luxembourg B 144.206.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signatures
<i>Administrateur

Référence de publication: 2014095869/12.
(140114325) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2014.

KKR International Flowers S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 63, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 185.972.

EXTRAIT

Il résulte d'un contrat de transfert de parts sociales signé en date du 20 juin 2014 que KKR European Fund III Limited

Partnership, associé de la Société, a transféré soixante-dix mille cent quarante-deux (70.142) parts sociales détenues dans
la Société à KKR Partners II (International) Limited Partnerhip, une limited liability company, ayant son siège social au
Ugland House, South Church Street, KYI-1104 George Town, Grand Cayman, et immatriculée auprès du Registrar of
Companies des Iles Caymans sous le numéro MC-20420.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 07 juillet 2014.

Référence de publication: 2014098351/16.
(140116580) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2014.

Foncier &amp; Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 7, place du Théâtre.

R.C.S. Luxembourg B 5.322.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires réunis à Luxembourg, le 26 juin 2014

réélit Administrateurs pour un an:
M. Gaston SCHWERTZER, docteur en droit, Medingen,
M. Jacquot SCHWERTZER, maître en sciences économiques, Schrassig,
M. Marc SCHWERTZER, commerçant Reckange/Mess,
réélit Commissaire pour un an:
La société DMS &amp; ASSOCIES, S.à.r.I., à L -1274 HOWALD, 23, rue des Bruyères.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue immédiatement après l'assemblée générale

Le Conseil d'Administration réélit pour un an M. Gaston SCHWERTZER Président, nomme pour un an M. Jacquot

SCHWERTZER Administrateur-délégué, nomme pour un an Mme Valérie WEBER Fondé de pouvoirs, et fixe les pouvoirs
comme suit:

a) la société est engagée en toutes circonstances par la seule signature du Président ou par la seule signature de

l'Administrateur-délégué ou par les signatures conjointes de trois Administrateurs, qui n'auront pas à justifier vis-à-vis
des tiers des pouvoirs en vertu desquels ils agissent.

b) pour la gestion journalière des affaires, la société est engagée pour des obligations ne dépassant pas 15.000,00 €

par la seule signature du fondé de pouvoirs.

Pour extraits conformes
Jacquot SCHWERTZER
<i>Administrateur-délégué

Référence de publication: 2014095875/26.
(140113877) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2014.

116696

L

U X E M B O U R G

Foncière de Seine S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 100.032.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 09 juillet 2014 que:
- Gestman S.A. a démissionné de son poste de commissaire.
- A été élue au poste de Commissaire en remplacement du commissaire démissionnaire:
* Gestal Sàrl, immatriculée au RCS de Luxembourg sous le numéro B 184722 avec siège social au 23, rue Aldringen -

L-1118 Luxembourg.

- Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2016.

Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2014099139/16.
(140118485) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2014.

EEE 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 114.000,00.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 132.810.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire des associés (l'«Assemblée») de la Société à Luxembourg en date

<i>du 7 juillet 2014

L'Assemblée a décidé de réélire Deloitte Audit, société à responsabilité limitée ayant son siège social au 560, rue de

Neudorf, L-2220 Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 67.895, réviseur d'entreprises agréé de la Société, pour une période venant à expiration à l'issue de l'assemblée générale
devant se tenir en l'année 2015 pour statuer sur l'approbation des comptes annuels au 31 décembre 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 juillet 2014.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2014099097/18.
(140117668) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2014.

Europa Rock S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 2.933.500,00.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 134.023.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait des résolutions adoptées par l'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société en date du 4 juillet 2014

L'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société a décidé en date du 4 juillet 2014 de:
1) prononcer la clôture de la liquidation de la Société, et
2) que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans au 68-70, boulevard de la

Pétrusse, L-2320 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 4 juillet 2014.

<i>Pour la Société
Signes S.A.
Vincent Goy
<i>Administrateur-délégué

Référence de publication: 2014099087/20.
(140118495) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2014.

116697

L

U X E M B O U R G

Face International S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6910 Roodt-sur-Syre, 2, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 80.138.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014095851/9.
(140114777) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2014.

FIDEURO, Société Anonyme Unipersonnelle.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-8011 Strassen, 283, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 151.304.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014095862/9.
(140114529) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2014.

European NPL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 31-33, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 121.186.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 27 juin 2014

L'assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société anonyme EUROPEAN NPL S.A., ayant son

siège social à Luxembourg, a définitivement cessé d'exister.

L'assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une période

de cinq (5) ans au siège de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juin 2014.

<i>Pour EUROPEAN NPL S.A.
DGAD INTERNATIONAL S.à r.l.
<i>Liquidateur

Référence de publication: 2014099091/18.
(140118816) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2014.

EEE 5 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 6.416.700,00.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 134.814.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire des associés (l'«Assemblée») de la Société à Luxembourg en date

<i>du 7 juillet 2014

L'Assemblée a décidé de réélire Deloitte Audit, société à responsabilité limitée ayant son siège social au 560, rue de

Neudorf, L-2220 Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 67.895, réviseur d'entreprises agréé de la Société, pour une période venant à expiration à l'issue de l'assemblée générale
devant se tenir en l'année 2015 pour statuer sur l'approbation des comptes annuels au 31 décembre 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 juillet 2014.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2014099098/18.
(140117667) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2014.

116698

L

U X E M B O U R G

Forum TFI Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 179.549.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014095843/10.
(140115088) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2014.

Franchise International (Luxembourg), Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 154.666.

Il est porté à la connaissance de tous que les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

Référence de publication: 2014095846/11.
(140114578) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2014.

Globec Industries, Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.

R.C.S. Luxembourg B 184.121.

L'adresse professionnelle de l’administrateur de catégorie B, Monsieur Alexander Tkachenko a changé:
- ancienne adresse: 6, rue Jean Engling, L-1466, Luxembourg;
- nouvelle adresse: 4, rue Jean Engling, L-1466, Luxembourg.

Luxembourg, le 02.07.2014.

Référence de publication: 2014095896/11.
(140114783) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2014.

Finbra S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 62.242.

<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration tenue en date du 30 mai 2014

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 30 mai 2014 que:
- le siège social de la société est transféré du 42-44 avenue de la gare L-1610 Luxembourg au 50, rue Charles Martel,

L-2134 Luxembourg, avec effet au 1 

er

 juin 2014.

- Les administrateurs M. Claude ZIMMER, M. Hendrik H.J. KEMMERLING et M. Rob SONNENSCHEIN sont domiciliés

professionnellement au 50, rue Charles Martel 1 

er

 étage, L-2134 Luxembourg et ce, avec effet au 1 

er

 juin 2014.

- L'administrateur LuxGlobal Management S.à r.l, société enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés

Luxembourg sous le numéro B159.893 est transféré au 50, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg et ce, avec effet au

er

 juin 2014. Représentant permanent M. Hendrik H.J. KEMMERLING domicilié professionnellement au 50, rue Charles

Martel, 1 

er

 étage L-2134 Luxembourg et ce, avec effet au 1 

er

 juin 2014.

A la date du 21.08.2013, démission d'un administrateur à savoir:
- Monsieur Marc THEISEN, administrateur, né le 05 novembre 1954 à Luxembourg (Luxembourg), domicilié profes-

sionnellement au 42-44, avenue de la gare L-1610 Luxembourg

Extrait sincère et conforme
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014095864/22.
(140114760) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2014.

116699

L

U X E M B O U R G

G-Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R.C.S. Luxembourg B 94.993.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014095887/9.
(140115007) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2014.

Fundo de Investimento Privado - Angola S.C.A., SICAV-SIF, Société en Commandite par Actions sous la

forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 151.239.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014095850/10.
(140114351) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2014.

Flex S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8362 Grass, 6, rue des Champs.

R.C.S. Luxembourg B 144.206.

<i>Extrait des résolutions

Il résulte d'une décision de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société en date du 20 mai 2014:
L'Assemblée confirme le renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Frédéric Laurent.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour le Conseil d'Administration
Signatures

Référence de publication: 2014095870/13.
(140114877) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2014.

Froidchapelle S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 40.843.

<i>Extrait de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société Froidchapelle SA qui s'est tenue à Luxembourg le 30 Juin

<i>2014 à 15.00 heures

[Omissis]

<i>Septième résolution

L'assemblée générale prend acte de la démission de l'administrateur Concetta Demarinis et décide de nommer en son

remplacement:

Julien Nicaud, né le 4 juin 1981 à Metz, France, résident professionnellement au 5, Avenue Gaston Diderich, L-1420

Luxembourg

Le mandat du nouveau administrateur prendra fin en même temps que les administrateurs déjà en fonction, à savoir

jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2018.

Luxembourg, le 30 juin 2014.

Pour copie conforme
<i>Pour le conseil d'administration
Xavier Mangiullo / Francesca Docchio
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2014095881/22.
(140114887) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2014.

116700

L

U X E M B O U R G

Monitchem Holdco 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 187.114.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-fourth day of June,
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

Was held

an extraordinary general meeting of the shareholder of Monitchem Holdco 2 S.A., a Luxembourg société anonyme,

incorporated by a notarial deed drawn up on 9 May 2014, having its registered office at 282, route de Longwy, L-1940
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies
under number B 187.114 (the “Company”) whose articles of association (the "Articles") have not been published yet in
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Memorial") and the Articles have not been amended since the
Company's incorporation.

The extraordinary general meeting of the Company (the "Meeting") elected as chairman Mr Gianpiero SADDI, em-

ployee, residing professionally in Luxembourg.

The chairman appointed as secretary Miss Marilyn KRECKE, employee, residing professionally in Luxembourg.
The Meeting elected as scrutineer Mr Gianpiero SADDI, prenamed.
The Meeting having thus been constituted, the chairman requested the notary to act that:
I. The name of the sole shareholder represented at the meeting by proxy (the "Sole Shareholder") and the number of

shares held by it are shown on an attendance list. This attendance list has been signed ne varietur together with the proxy
form on behalf of the Sole Shareholder represented at the meeting by the proxyholder, by the notary as well as the
chairman, the scrutineer and the secretary.

II. The attendance list shows that the Sole Shareholder holding all of the shares representing the whole share capital

of the Company is represented at the meeting by proxy. The Sole Shareholder has declared that it has been duly convened
to  the  meeting  in  accordance  with  the  requirements  of  the  Luxembourg  laws.  The  Meeting  was  therefore  properly
constituted to validly consider all items of the agenda.

III. The agenda of the Meeting was the following:

<i>Agenda

(1) Decision to change the nominal value of the shares of the Company from one Eurocent (EUR 0.01) each to one

Euro (EUR 1.-) each.

(2) Decision to increase the issued share capital of the Company by an amount of nine hundred sixty-nine thousand

Euro (EUR 969,000.-) in order to raise it from its present amount of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) to one
million Euro (EUR 1,000,000.-) by creating and issuing nine hundred sixty-nine thousand (969,000) new shares with a
nominal value of one Euro (EUR 1.-), each having such rights and obligations as set forth in the articles of association of
the Company (the "Articles") (the "New Shares") and to be issued and fully paid up with a share premium amounting to
two hundred and thirty-two million one hundred and seventy-five thousand one hundred Euro (EUR 232,175,100.-) (the
"Share Premium") by way of contribution in cash of an amount of two hundred and twenty-one million six hundred and
two thousand nine hundred and sixty-nine Euro (EUR 221,602,969) and a contribution in kind consisting of claims of the
Sole Shareholder of an amount of eleven million five hundred and forty-one thousand one hundred and thirty-one Euro
(EUR 11,541,131.-).

Subscription and payment for the New Shares by the Sole Shareholder.
(3) Decision to amend article 5.1 of the Articles so as to reflect the above resolutions.
(4) Miscellaneous.
IV. Then the Sole Shareholder, after deliberation, passed the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolved to change the nominal value of the shares of the Company from one Eurocent (EUR

0.01) each to one Euro (EUR 1.-) each and to subsequently convert the existing three million one hundred thousand
(3,100,000) existing shares into thirty-one thousand (31,000) shares, with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolved to increase the issued share capital of the Company by an amount of nine hundred

sixty-nine thousand Euro (EUR 969,000.-)

in order to raise it from its present amount of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) to one million Euro (EUR

1,000,000.-)

116701

L

U X E M B O U R G

by creating and issuing nine hundred sixty-nine thousand (969,000) new shares with a nominal value of one Euro (EUR

1.-), each having such rights and obligations as set forth in the articles of association of the Company (the "Articles") (the
"New Shares")

and to be issued and fully paid up with a share premium amounting to two hundred and thirty-two million one hundred

and seventy-five thousand one hundred Euro (EUR 232,175,100.-) (the "Share Premium")

by way of contribution in cash of an amount of two hundred and twenty-one million six hundred and two thousand

nine hundred and sixty-nine Euro (EUR 221,602,969) and a contribution in kind consisting of claims of the Sole Shareholder
of an amount of eleven million five hundred and forty-one thousand one hundred and thirty-one Euro (EUR 11,541,131.-).

<i>Subscription and Payment

The Sole Shareholder declared to subscribe for all the New Shares with the Share Premium and to fully pay them up

by a contribution in cash of an amount of two hundred and twenty-one million six hundred and two thousand nine hundred
and sixty-nine Euro (EUR 221,602,969) and a contribution in kind consisting of claims of the Sole Shareholder of an amount
of eleven million five hundred and forty-one thousand one hundred and thirty-one Euro (EUR 11,541,131.-);

proof that the two hundred and twenty-one million six hundred and two thousand nine hundred and sixty-nine Euro

(EUR 221,602,969) in respect of this cash contribution, being at the disposal of the Company, has been given to the
Notary, who expressly acknowledged receipt of the proof of payment.

In accordance with articles 32-1 and 26-1 (1) of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended,

the existence and the valuation of the contributions in kind to the Company result from a valuation report issued on 24
June 2014 by Price Waterhouse Coopers Luxembourg, réviseur d'entreprises agrée, which concludes as follows:

Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the global value of the contri-

bution in kind does not correspond at least to the number and the nominal value, increased by the share premium, of
the shares to be issued in counterpart.

Said report, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary,

will remain attached to the present deed in order to be registered with it.

<i>Third resolution

The Sole Shareholder resolved to amend article 5.1 of the Articles to reflect the above change of the nominal value

of the shares and the share capital increase, so that henceforth it shall read as follows:

5.1. The subscribed share capital of the Company is one million Euro (EUR 1,000,000.-) divided into one million

(1,000,000) shares with a par value of one Euro (EUR 1.-) each (the "Shares"), all of which are fully paid up. In these
Articles,  "Shareholders"  means  the  holders  at  the  relevant  time  of  the  Shares  and  "Shareholder"  shall  be  construed
accordingly."

<i>Costs

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at approximately EUR 6500.

Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting was closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing persons,
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be prevail to the fullest extent
permitted by applicable law.

Whereof, the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this

document.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status and

residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mil quatorze, le vingt-quatre juin,
Par-devant Nous Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

S'est tenue

une assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire de Monitchem Holdco 2 S.A., une société anonyme de droit

luxembourgeois, constituée suivant un acte notarié en date du 9 mai 2014 ayant son siège social au 282, route de Longwy,
L-1940 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le
numéro B 187.114 (la "Société"), dont les statuts (les "Statuts") n'ont pas encore été publiés au Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations (le "Mémorial "), et dont les Statuts n'ont pas été modifiés depuis.

L'assemblée générale extraordinaire (l'"Assemblée") élit comme président Mr Gianpiero SADDI, employé, demeurant

professionnellement à Luxembourg.

116702

L

U X E M B O U R G

Le président nomme en qualité de secrétaire de séance Melle Marilyn KRECKE, employée, demeurant professionnel-

lement à Luxembourg.

L'Assemblée élit comme scrutateur Mr Gianpiero SADDI, précité.
Le bureau de l'Assemblée ayant été constitué, le Président déclare et requiert du notaire instrumentant de prendre

acte que:

I. Le nom de l'actionnaire unique représenté à l'assemblée par un mandataire (l'"Actionnaire Unique") et le nombre

d'actions qu'il détient est mentionné sur la liste de présence à la fin de ce procès-verbal. Cette liste de présence a été
signée ne varietur avec la procuration par l'Actionnaire Unique représenté à l'assemblée par le mandataire, le notaire
ainsi que le président, le scrutateur et le secrétaire.

II. La liste de présence montre que l'Actionnaire Unique détenant toutes les actions représentant la totalité du capital

social de la Société est représenté par un mandataire. L'Actionnaire Unique a déclaré qu'il a été dûment convoqué à
l'assemblée en conformité avec les conditions requises par les lois luxembourgeoises. L'Assemblée est donc valablement
constituée pour valablement délibérer sur l'ordre du jour.

III. L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. Décision de changer la valeur nominale des actions de la Société d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune à un euro

(EUR 1,-) chacune.

2. Décision d'augmenter le capital social émis de la Société d'un montant de neuf cent soixante-neuf mille euros (EUR

969.000,-), afin de le porter de son montant actuel de trente-et-un mille euros (EUR 31.000,-) à un million euros (EUR
1.000.000.-), par la création et l'émission de neuf cent soixante-neuf mille (969.000) nouvelles actions ayant une valeur
nominale d'un euro (EUR 1,-), chacune ayant les droits et obligations tels que définis dans les Statuts (les "Nouvelles
Actions") et devant être émises et entièrement libérées avec une prime d'émission d'un montant de deux cent trente-
deux million cent soixante-quinze mille cent euros (EUR 232.175.100,-) par voie d'apport en numéraire d'un montant de
deux cent vingt-et-un millions six cent deux mille neuf cent soixante-neuf euros (EUR 221.602.969,-) et en nature con-
sistant en des créances de l'Actionnaire Unique d'un montant de onze million cinq cent quarante-et-un mille cent trente-
et-un euros (EUR 11.541.131,-).

Souscription et paiement des Nouvelles Actions par l'Actionnaire Unique.
3. Décision de modifier l'article 5.1 des Statuts afin de refléter les résolutions précédentes.
4. Divers.
IV. Après délibération, l'Actionnaire Unique adopte les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé Unique a décidé de changer la valeur nominale des actions de la Société d'un centime d'euro (EUR 0,01)

chacune à un euro (EUR 1,-) chacune et de convertir les trois millions cent mille (3.100.000) actions existantes en trente-
et-un mille (31.000) actions avec une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune.

<i>Deuxième résolution

L'Associé Unique a décidé d'augmenter le capital social émis de la Société d'un montant de neuf cent soixante-neuf

mille euros (EUR 969.000,-),

afin de le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) à un million euros (EUR 1.000.000.-),
par la création et l'émission de neuf cent soixante-neuf mille (969.000) nouvelles actions ayant une valeur nominale

d'un euro (EUR 1,-), chacune ayant les droits et obligations tels que définis dans les Statuts (les "Nouvelles Actions")

et devant être émises et entièrement libérées avec une prime d'émission d'un montant de deux cent trente-deux

million cent soixante-quinze mille cent euros (EUR 232.175.100,-) par voie d'apport en numéraire d'un montant de deux
cent vingt-et-un million six cent deux mille neuf cent soixante-neuf euros (EUR 221.602.969,-)

et en nature consistant en des créances de l'Actionnaire Unique d'un montant de onze millions cinq cent quarante-et-

un mille cent trente-et-un euros (EUR 11.541.131,-).

<i>Souscription et paiement

L'Actionnaire Unique a déclaré souscrire à toutes les Nouvelles Actions avec la Prime d'Emission et d'entièrement les

libérer par un apport en numéraire deux cent vingt et un millions six cent deux mille neuf cent soixante-neuf euros (EUR
221.602.969,-) et par voie d'apport en nature consistant en des créances de l'Actionnaire Unique d'un montant de onze
million cinq cent quarante-et-un mille cent trente et un euros (EUR 11.541.131,-); la preuve que deux cent trente-deux
million cent soixante-quinze mille cent euros (EUR 232.175.100,-) en rapport avec l'apport en numéraire qui est à la libre
disposition de la Société, a été présentées au notaire soussigné qui reconnaît expressément avoir reçu la preuve du
paiement.

116703

L

U X E M B O U R G

Conformément aux articles 32-1 et 26-1 (1) de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que

modifiée, l'existence et l'évaluation de 'apport en nature de la Société résulte d'un rapport d'évaluation émis le 24 juin
2014 par Price Waterhouse Coopers Luxembourg, réviseur d'entreprises agrée, qui a la conclusion suivante:

Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the global value of the contri-

bution in kind does not correspond at least to the number and the nominal value, increased by the share premium, of
the shares to be issued in counterpart.

Ledit rapport, après avoir été signé ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant,

restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités d'enregistrement.

<i>Troisième résolution

L'Actionnaire Unique décide de modifier l'article 5.1 des Statuts pour refléter le changement de la valeur nominale des

actions et l'augmentation de capital, de sorte que le nouvel article 5.1 se lira comme suit:

5. Capital social.
5.1 Le capital social souscrit de la Société est fixé à un million euros (EUR 1.000.000,-), représenté par un million

(1.000.000) actions ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune (les "Actions"), qui ont toutes été intégralement
libérées. Dans les présents Statuts, "Actionnaires" signifie les détenteurs au moment pertinent des Actions et "Actionnaire"
doit être interprété conformément."

<i>Coûts

Les frais, dépenses et rémunérations ou charges de quelque forme que cela soit qui devront être supportés par la

Société comme résultant du présent acte sont estimés à approximativement EUR 6500.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne n'ayant soulevé d'autres points pour discussion par l'assemblée, l'as-

semblée est close.

Le notaire, qui comprend et parle l'anglais, déclare que le présent acte est rédigé en anglais suivi par une version

française, et qu'à la demande des personnes comparantes, en cas de divergence entre le texte français et le texte anglais,
le texte anglais fera foi dans toute la mesure permise par la loi applicable.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, le jour mentionné en haut de ce document.
Et après lecture faite aux parties comparantes, qui sont connues par le notaire par leurs noms de famille, prénom usuel,

état et demeure, les parties comparantes ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: G. Saddi, M. Krecké et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 03 juillet 2014. LAC/2014/30939. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 juillet 2014.

Référence de publication: 2014098443/196.
(140116858) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2014.

Digital Services XXV (GP) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 188.497.

STATUTES

In the year two thousand and fourteen, on the eighteenth day of June.
Before us Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Digital Services XXV S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of Grand

Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg,
the registration of which with the Luxembourg Trade and Companies’ Register is pending,

here represented by Mr. Luis AGUERRE ENRÍQUEZ, Doctor en Derecho, residing in Luxembourg,, by virtue of a

proxy, given in Berlin, Germany, on 18. June 2014, and in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 18. June 2014.

Said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to

this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such  appearing  party  has  requested  the  officiating  notary  to  enact  the  deed  of  incorporation  of  a  private  limited

company (société à responsabilité limitée) which it wishes to incorporate with the following articles of association:

116704

L

U X E M B O U R G

A. Name - Purpose - Duration - Registered office

Art. 1. Name - Legal Form. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name

Digital Services XXV (GP) S.à r.l. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915
concerning commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.

Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign

companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio in view of its realisation by sale, exchange or otherwise.

2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it

holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the
Company.

2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by

issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.

2.4 The Company may also act as a partner with unlimited or limited liability for the debts and obligations of any

Luxembourg or foreign entity.

2.5 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities

which it considers useful for the accomplishment of these purposes.

Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of

managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution
of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution

of the board of managers.

4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances

or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
traordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwiths-
tanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

B. Share capital - Shares

Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), represented by twelve

thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.

5.2 The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.3 The Company may redeem its own shares.

Art. 6. Shares.
6.1 The Company’s share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of

the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.

Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection

by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.

7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall

appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.

116705

L

U X E M B O U R G

7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given

by the shareholders at a majority of three quarters of the share capital.

7.5 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of

the transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

7.6 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject

to the approval of such transfer given by the surviving shareholders at a majority of three quarters of the share capital.
Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving
spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.

C. Decisions of the shareholders

Art. 8. Collective decisions of the shareholders.
8.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles

of association.

8.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
8.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise

conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case,
each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his
vote in writing.

8.4 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of

shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by
the sole shareholder.

Art. 9. General meetings of shareholders. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, at least

one general meeting of shareholders shall be held within six (6) months of the end of each financial year in Luxembourg
at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the convening notice of such meeting.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices
of meeting. If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived
any convening requirement, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 10. Quorum and vote.
10.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
10.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company’s

shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share
capital. If this majority is not reached in a first meeting or proposed written resolution, the shareholders may be convened
a second time with the same agenda or receive such proposed written resolution a second time by registered letter,
decisions are validly adopted in so far as they are adopted by a majority of the votes validly cast whichever is the fraction
of the share capital represented.

Art. 11. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.

Art. 12. Amendments of the articles of association. Any amendment of the articles of association requires the approval

of (i) a majority of shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.

D. Management

Art. 13. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
13.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers

form a board of managers.

13.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not

expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of
association is to be construed as a reference to the “sole manager”.

13.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any

actions necessary or useful to fulfil the Company’s corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the
Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.

Art. 14. Appointment, removal and term of office of managers.
14.1 The manager(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remune-

ration and term of office.

14.2 The managers shall be appointed and may be removed from office at any time, with or without cause, by a decision

of the shareholders representing more than half of the Company’s share capital.

116706

L

U X E M B O U R G

14.3 The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two (2) different classes, being class A

managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant
shareholders resolutions and the managers be identified with respect to the class they belong.

Art. 15. Vacancy in the office of a manager.
15.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or

otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the  replaced  manager by  the remaining managers  until  the next meeting  of shareholders  which  shall  resolve on the
permanent appointment, in compliance with the applicable legal provisions.

15.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company’s sole manager, such vacancy must be filled without undue

delay by the general meeting of shareholders.

Art. 16. Convening meetings of the board of managers.
16.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held

at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.

16.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four (24) hours at

least in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document
being sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location
determined in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.

16.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive

any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of
managers.

Art. 17. Conduct of meetings of the board of managers.
17.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not

need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

17.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may

appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any
such meeting.

17.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either

in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.

17.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other

means of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis
and allowing an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a
participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.

17.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or

represented at a meeting of the board of managers.

17.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,

if any, shall not have a casting vote. In the event where the general meeting of shareholders has appointed different classes
of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only be validly
taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which may be
represented).

17.7. The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in

writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be
the date of the last signature.

Art. 18. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
18.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by

the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. In the event the general meeting of
shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) under the joint
signature of one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation). Copies or excerpts
of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if any, or
by any two (2) managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers
(namely class A manager and class B manager) under the joint signatures of one (1) class A manager and one (1) class B
manager (including by way of representation).

18.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or

excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.

116707

L

U X E M B O U R G

Art. 19. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the

signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers;
in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers
and class B managers), the Company will only be validly bound by the joint signatures of at least one (1) class A manager
and one (1) class B manager (including by way of representation) or (ii) by the joint signatures or the sole signature of
any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such
delegation.

E. Audit and supervision

Art. 20. Auditor(s).
20.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company

shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.

20.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting

of shareholders.

20.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
20.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d’entreprises agréé

(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies’ register and the
accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.

20.5. An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its

approval.

F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends

Art. 21. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end

on the thirty-first of December of the same year.

Art. 22. Annual accounts and allocation of profits.
22.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of

the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.

22.2. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve.

This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten
per cent (10%) of the share capital of the Company.

22.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the

contributing shareholder agrees with such allocation.

22.4 In case of a share capital reduction, the Company’s legal reserve may be reduced in proportion so that it does

not exceed ten per cent (10%) of the share capital.

22.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the

remainder of the Company’s profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.

22.6 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.

Art. 23. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
23.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared

by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may
not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable
reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles
of association do not allow to be distributed.

23.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the share-

holders subject to the provisions of the Law and these articles of association.

G. Liquidation

Art. 24. Liquidation.
24.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the

liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders
deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided,
the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the
Company.

24.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the shareholders in proportion to the number of shares of the Company held by them.

116708

L

U X E M B O U R G

H. Final clause - Governing law

Art. 25. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance

with the Law.

<i>Transitional provisions

1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 31 December

2014.

2. Interim dividends may be distributed during the Company’s first financial year.

<i>Subscription and payment

The twelve thousand five hundred (12,500) shares issued have been subscribed by Digital Services XXV S.à r.l., afo-

rementioned, for the price of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500).

The shares so subscribed are fully paid-up by a contribution in cash so that the amount of twelve thousand five hundred

euro (EUR 12,500) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

The total contribution in the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) is entirely allocated to the

share capital.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be

borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately one thousand Euros (EUR
1,000.-).

<i>Resolution of the sole shareholder

The incorporating shareholder, representing the entire share capital of the Company and having waived any convening

requirements, has thereupon passed the following resolutions:

1. The address of the registered office of the Company is set at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of

Luxembourg.

2. The following person is appointed as class A manager of the Company for an unlimited term:
- Mr Christian Senitz, born in Aschersleben, Germany, on 27 January 1978, professionally residing at Johannisstrasse

20, D-10117 Berlin.

The following person is appointed as class B manager of the Company for an unlimited term:
- Mr Ulrich Binninger, born in Trier, Germany, on 30 August 1966, professionally residing at 19, rue des Lilas, L-8035

Strassen, Luxembourg.

<i>Statement

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,

this deed is worded in English followed by a German translation; at the request of the same appearing party and in case
of divergence between the English and the German text, the English version shall prevail.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this

document.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name

and residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahr zweitausendvierzehn, am achtzehnten Juni.
Vor uns, Carlo WERSANDT, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

IST ERSCHIENEN:

Digital Services XXV S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), gegründet

und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Groß-
herzogtum Luxemburg, deren Eintragung im Luxemburger Handels-und Gesellschaftsregister noch aussteht,

hier vertreten durch Herrn Luis AGUERRE ENRÍQUEZ, Doctor en Derecho, wohnhaft in Luxemburg, gemäß einer

Vollmacht ausgestellt in Berlin, Deutschland, am 18. Juni 2014 und in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, am 18.
Juni 2014.

Besagte Vollmacht, welche vom Bevollmächtigten der erschienenen Partei und dem unterzeichnenden Notar ne vari-

etur paraphiert wurde, wird der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.

Die erschienene Partei hat den amtierenden Notar ersucht, die Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung

(société à responsabilité limitée) zu beurkunden, welche sie mit der folgenden Satzung gründen möchte:

116709

L

U X E M B O U R G

A. Name - Zweck - Dauer - Sitz

Art. 1. Name - Rechtsform. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée)

mit dem Namen Digital Services XXV (GP) S.à r.l. (die „Gesellschaft”), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10.
August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Ge-

sellschaften, sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung
oder auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung,
Kontrolle und Entwicklung ihrer Beteiligungen im Hinblick auf deren Verwertung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige
Art.

2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder

Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören Garantien geben,
Sicherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.

2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere

durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und
Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheinen bzw. Wertpapieren.

2.4 Die Gesellschaft kann auch als Gesellschafterin für die Schulden und Verpflichtungen jeglicher luxemburgischen

und ausländischen Gesellschaft mit unbeschränkter oder beschränkter Haftung handeln.

2.5 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur vorneh-

men, sowie solche, welche das geistige Eigentum betreffen oder im Zusammenhang mit Grundeigentum stehen, und die
ihr zur Erreichung dieser Zwecke förderlich erscheinen.

Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden,

welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird.

Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Rates der Geschäftsführer

verlegt werden. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderli-
chen Art und Weise gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer im

Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.

4.4 Sollte der Rat der Geschäftsführer entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale

Entwicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an
ihrem  Gesellschaftssitz  beeinträchtigen  könnten,  so  kann  der  Gesellschaftssitz  bis  zur  endgültigen  Beendigung  dieser
außergewöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben
keine Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes
eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1  Das  Gesellschaftskapital  der  Gesellschaft  beträgt  zwölftausendfünfhundert  Euro  (EUR  12.500)  bestehend  aus

zwölftausendfünfhundert (12.500) Anteilen mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Anteil.

5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-

zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.

5.3 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen.

Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit jeweils dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht über-

schreiten darf.

6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs, die Insolvenz

oder ein vergleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.

116710

L

U X E M B O U R G

Art. 7. Anteilsregister - Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden

kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.

7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten

wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft
ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.

7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.
7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern mit

einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden.

7.5 Jede Übertragung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten gemäß Artikel 1690 des Code Civil

wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung zugestimmt
hat.

7.6 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters an neue Gesellschafter nur mit Zustimmung von

Gesellschaftern mit einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden. Eine derartige Zu-
stimmung ist nicht erforderlich, wenn die Anteile Eltern, Nachkommen oder dem/der überlebenden Ehepartner/in oder
jedem anderen gesetzlichen Erben des verstorbenen Gesellschafters übertragen werden.

C. Entscheidungen der Gesellschafter

Art. 8. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
8.1 Die Gesellschafterversammlung ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch das Gesetz und diese Satzung

ausdrücklich vorbehalten sind.

8.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.
8.3 Falls und solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, dürfen gemeinsame Ent-

scheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung vorbehalten wären, schriftlich gefasst werden. In diesem
Fall erhält jeder Gesellschafter den Text der zu fassenden Beschlüsse oder Entscheidungen in ausformulierter Form und
übt sein Stimmrecht schriftlich aus.

8.4 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschriften

des Abschnitts XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jede Bezugnahme auf die „Gesell-
schafterversammlung“ in der vorliegenden Satzung als Bezugnahme auf den Alleingesellschafter, je nach Zusammenhang
und soweit anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingesellschafter
ausgeübt.

Art. 9. Gesellschafterversammlung. Falls die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, muss jährlich

innerhalb von sechs (6) Monaten vor dem Ende des Geschäftsjahres mindestens eine Gesellschafterversammlung in Lu-
xemburg am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort abgehalten werden, wie in der Einberufungsbekanntmachung
zu dieser Versammlung genauer bestimmt. Andere Gesellschafterversammlungen finden an dem Ort und zu der Zeit statt,
welche in der entsprechenden Einberufungsbekanntmachung genauer bestimmt werden. Falls alle Gesellschafter in einer
Versammlung anwesend oder vertreten sind und auf sämtliche Einberufungsformalitäten verzichtet haben, kann die Ge-
sellschafterversammlung auch ohne vorherige Ankündigung oder Veröffentlichung abgehalten werden.

Art. 10. Quorum und Abstimmung.
10.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.
10.2 Vorbehaltlich anderer Regelungen dieser Satzung oder des Gesetzes, die ein höheres Mehrheitsverhältnis vor-

sehen, bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von Gesellschaftern, die mehr als die
Hälfte des Gesellschaftskapitals halten. Falls diese Mehrheit in einer ersten Gesellschafterversammlung oder einer ersten
schriftlichen Konsultation der Gesellschafter nicht erreicht wird, können die Anteilseigner ein weiteres Mal mit derselben
Tagesordnung einberufen werden oder per Einschreiben dieselben schriftlichen Beschlussvorschläge erhalten und Ent-
scheidungen werden wirksam mit der Mehrheit der wirksam abgegebenen Stimmen gefasst, unabhängig vom Anteil des
durch sie vertretenen Gesellschaftskapitals.

Art. 11. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.

Art. 12. Änderung der Satzung. Eine Änderung der Satzung erfordert die Zustimmung (i) einer Mehrheit der Gesell-

schafter, (ii) die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertritt.

D. Geschäftsführung

Art. 13. Befugnisse des alleinigen Geschäftsführers - Zusammensetzung und Befugnisse des Rates der Geschäftsführer.
13.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Ge-

schäftsführer hat, bilden diese einen Rat der Geschäftsführer.

116711

L

U X E M B O U R G

13.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „alleiniger Ge-

schäftsführer“ nicht ausdrücklich verwendet wird, ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Rat der Geschäftsführer“
als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer“ auszulegen.

13.3 Der Rat der Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, im Namen der Gesellschaft zu handeln

und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.

Art. 14. Ernennung, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
14.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung ernannt, welche ihre Bezüge und

Amtszeit festlegt.

14.2 Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund durch einen Beschluss von Gesellschaftern, die mehr als die

Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, ernannt oder abberufen werden.

14.3 Die Gesellschafterversammlung kann die Ernennung von Geschäftsführern zwei (2) unterschiedlicher Kategorien

beschließen, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Eine solche Klassifizierung
der Geschäftsführer muss ordnungsgemäß im Protokoll der betreffenden Gesellschafterbeschlüsse festgehalten und die
Geschäftsführer der Kategorie, der sie angehören, zugeordnet werden.

Art. 15. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
15.1 Scheidet ein Geschäftsführer durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Insolvenz, Rücktritt oder aus einem anderen Grund

aus seinem Amt aus, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen die ur-
sprüngliche Amtszeit nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesellschafterversammlung ausgefüllt werden,
welche im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die endgültige Ernennung entscheidet.

15.2 Für  den  Fall,  dass  der  alleinige  Geschäftsführer aus  seinem Amt  ausscheidet, muss die  frei gewordene  Stelle

unverzüglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.

Art. 16. Einladung zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
16.1 Der Rat der Geschäftsführer versammelt sich auf Einberufung eines beliebigen Geschäftsführers. Die Sitzungen

des Rates der Geschäftsführer finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.

16.2  Die  Geschäftsführer  werden  mindestens  vierundzwanzig  (24)  Stunden  vor  dem  für  die  Sitzung  anberaumten

Zeitpunkt zu jeder Sitzung des Rates der Geschäftsführer schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe
der Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Geschäftsführer
schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abgege-
ben haben, wobei eine Kopie eines solchen unterzeichneten Dokuments ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung
zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss
des Rates der Geschäftsführer bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.

16.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle

Einladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Rates
der Geschäftsführer diesen zugestimmt und diese unterzeichnet haben.

Art. 17. Durchführung von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
17.1 Der Rat der Geschäftsführer kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Rat der Ge-

schäftsführer kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise selbst ein Geschäftsführer sein muss
und der für die Protokollführung der Sitzungen des Rates der Geschäftsführer verantwortlich ist.

17.2 Sitzungen des Rates der Geschäftsführer werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Rates der Ge-

schäftsführer geleitet. In dessen Abwesenheit kann der Rat der Geschäftsführer einen anderen Geschäftsführer durch
einen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Mitglieder als Vorsitzenden pro tempore ernennen.

17.3 Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer teilnehmen, indem er einen anderen

Geschäftsführer schriftlich, per Faxschreiben, EMail oder durch ein anderes vergleichbares Kommunikationsmittel be-
vollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Geschäftsführer kann einen
oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.

17.4 Eine Sitzung des Rates der Geschäftsführer kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein

anderes Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu
hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel
ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung gilt als am Sitz der Ge-
sellschaft abgehalten.

17.5 Der Rat der Geschäftsführer kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest die Mehrheit seiner

Mitglieder in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.

17.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Rates der Geschäftsführer

teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden,
hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme. Sofern die Gesellschafterversammlung jedoch unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer

116712

L

U X E M B O U R G

der Kategorie B), werden Beschlüsse des Rates der Geschäftsführer nur dann wirksam gefasst, wenn sie von der Mehrheit
der Geschäftsführer einschließlich mindestens eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsführers der
Kategorie B (oder deren Vertreter) gefasst werden.

17.7 Der Rat der Geschäftsführer kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung,

per Faxschreiben, E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Jeder Geschäftsführer kann seine
Zustimmung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreffenden
Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.

Art. 18. Protokoll von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer - Protokoll der Entscheidungen des alleinigen Ge-

schäftsführers.

18.1 Das Protokoll einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer wird vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer,

falls vorhanden, oder, im Falle seiner Abwesenheit, vom Vorsitzenden pro tempore und dem Schriftführer (falls vorhan-
den) oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche
Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kate-
gorie B), werden solche Protokolle von einem (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einem (1) Geschäftsführer der
Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsver-
fahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer, falls
vorhanden, oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden solche Kopien oder Auszüge von einem (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einem (1)
Geschäftsführer der Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet.

18.2 Die Entscheidungen des alleinigen Geschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom alleinigen

Geschäftsführer unterzeichnet wird. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet.

Art. 19. Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Um-

ständen  (i)  durch  die  Unterschrift  des  alleinigen  Geschäftsführers  oder,  für  den  Fall,  dass  die  Gesellschaft  mehrere
Geschäftsführer hat, durch die gemeinsame Unterschrift von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern wirksam verpflichtet;
sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäfts-
führer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B), wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift
mindestens eines (1) Geschäftsführers der Kategorie A und eines (1) Geschäftsführers der Kategorie B (oder deren
Vertreter) oder (ii) durch die gemeinsamen Unterschriften oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/denen
eine Unterschriftsbefugnis durch den Rat der Geschäftsführer übertragen worden ist, wirksam verpflichtet.

E. Aufsicht und Prüfung der Gesellschaft

Art. 20. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
20.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der

Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)). Die Gesellschafterversammlung
ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.

20.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
20.3 Der Rechnungsprüfer hat ein unbeschränktes Recht der permanenten Überprüfung und Kontrolle aller Geschäfte

der Gesellschaft.

20.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember

2002  betreffend  das  Handelsregister  und  die  Buchhaltung  und  den  Jahresabschluss  von  Unternehmen,  in  der  jeweils
gültigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseur(s) d’entreprises agréé(s)) ernennen, entfällt
die Funktion des Rechnungsprüfers.

20.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die

Gesellschafterversammlung abberufen werden.

F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinne - Abschlagsdividenden

Art. 21. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am

einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

Art. 22. Jahresabschluss und Gewinne.
22.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Rat der Geschäftsführer erstellt im

Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und
Verlustrechnung.

22.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage

der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.

22.3  Durch  einen  Gesellschafter  erbrachte  Einlagen  in  Rücklagen  können  mit  Zustimmung  dieses  Gesellschafters

ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.

116713

L

U X E M B O U R G

22.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage entsprechend herabgesetzt

werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.

22.5 Auf Vorschlag des Rates der Geschäftsführer bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den ge-

setzlichen  Vorschriften  und  den  Bestimmungen  dieser  Satzung,  wie  der  verbleibende  Bilanzgewinn  der  Gesellschaft
verwendet werden soll.

22.6 Ausschüttungen an die Gesellschafter erfolgen proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehalt-

enen Anteile.

Art. 23 .Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
23.1 Der Rat der Geschäftsführer kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche

vom Rat der Geschäftsführer vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur
Verfügung stehen. Der ausschüttbare Betrag darf nicht die Summe der seit dem Ende des vergangenen Geschäftsjahres
angefallenen Gewinne, gegebenenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne und ausschüttbare Rücklagen, beziehungs-
weise vermindert durch vorgetragene Verluste und Summen, die einer Rücklage zugeführt werden, welche nach dem
Gesetz von 1915 oder dieser Satzung nicht ausgeschüttet werden darf, übersteigen.

23.2 Das Agio, andere Kapitalreserven oder andere ausschüttbare Rücklagen können im Einklang mit den Bestimmun-

gen des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

G. Liquidation

Art. 24. Liquidation.
24.1 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Liquidation durch einen

oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, die über die Auflö-
sung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit nichts anderes
bestimmt wird, haben die Liquidatoren die weitestgehenden Rechte für die Verwertung der Vermögenswerte und die
Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

24.2 Der sich nach Verwertung der Vermögenswerte und Tilgung der Verbindlichkeiten ergebende Überschuss wird

an die Gesellschafter proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehaltenen Anteile verteilt.

H. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht

Art. 25 Anwendbares Recht. Für alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten gelten die Regelungen des

Gesetzes von 1915.

<i>Übergangsbestimmungen

1. Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember

2014.

2. Abschlagsdividenden können auch während des ersten Geschäftsjahres der Gesellschaft ausgeschüttet werden.

<i>Zeichnung und Zahlung

Die zwölftausendfünfhundert (12.500) ausgegebenen Anteile wurden von Digital Services XXV S.à r.l., vorbenannt,

zum Preis von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) gezeichnet.

Die Einlage für so gezeichnete Anteile wurde vollständig in bar erbracht, so dass der Gesellschaft ein Betrag in Höhe

von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) zur Verfügung steht, was dem unterzeichnenden Notar nachgewiesen
wurde.

Die gesamte Einlage in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) wird vollständig dem Gesellschaftskapital

zugeführt.

<i>Auslagen

Die der Gesellschaft aufgrund oder im Zusammenhang mit ihrer Gründung entstandenen Kosten, Gebühren, Honorare

und Auslagen werden auf eintausend Euro (EUR 1.000) geschätzt.

<i>Beschlüsse des Alleingesellschafters

Der Gründungsgesellschafter, welcher das gesamte Gesellschaftskapital repräsentiert und welcher auf eine formelle

Einberufungsbekanntmachung verzichtet, hat daraufhin folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Sitz der Gesellschaft ist in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
2. Die folgende Person wird für unbegrenzte Zeit als Geschäftsführer der Kategorie A der Gesellschaft ernannt:
- Herr Christian Senitz, geboren am 27. Januar 1978 in Aschersleben, Deutschland, geschäftsansässig in Johannisstraße

20, D-10117 Berlin.

Die folgende Person wird für unbegrenzte Zeit als Geschäftsführer der Kategorie B der Gesellschaft ernannt:
- Herr Ulrich Binninger, geboren am 30. August 1966 in Trier, Deutschland, geschäftsansässig in 19, rue des Lilas,

L-8035 Strassen, Luxemburg.

116714

L

U X E M B O U R G

<i>Erklärung

Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache beherrscht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende

Urkunde auf Verlangen der erschienenen Partei auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung;
auf Verlangen besagter erschienener Partei und im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen
Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.

WORÜBER diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen wurde.
Die vorstehende Urkunde ist dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei, welcher dem Notar mit Namen, Vorn-

amen und Wohnsitz bekannt ist, verlesen und vom Notar gemeinsam mit diesem Bevollmächtigten unterzeichnet worden.

Signé: L. AGUERRE ENRÍQUEZ, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 juin 2014. LAC/2014/28987. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 11 juillet 2014.

Référence de publication: 2014100940/577.
(140120156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

DRC2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 2, Am Hock.

R.C.S. Luxembourg B 188.526.

STATUTS

L’an deux mille quatorze, le premier juillet.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem.

A COMPARU:

D.R.C. S.A., une société anonyme luxembourgeoise, ayant son siège social au 2, Am Hock, L-9991 Weiswampach,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 83.889,

ici représentée par Madame Céline PEIFFER, employée, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
en vertu de procuration donnée en juin 2014.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la mandataire de la partie comparante et le notaire

instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une

Société anonyme dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1 

er

 .  Entre les parties ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des actions

ci-après créées, il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de DRC2 S.A..

Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Weiswampach.
Le Conseil d’Administration pourra établir des succursales ou bureaux aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg

qu’à l’étranger.

Au cas où le Conseil d’Administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre
ce siège et l’étranger se produiraient ou seraient imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète des circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la nationalité
de  la  société,  laquelle,  nonobstant  ce  transfert  provisoire  du  siège,  restera  luxembourgeoise.  Pareille  déclaration  de
transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes exécutifs de la société ayant
qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans d’autres sociétés

ou entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir
par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation,
obligations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité
publique ou privée, y compris des sociétés de personnes. Elle pourra participer dans la création, le développement, la
gestion et le contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un
portefeuille de brevets ou d’autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder, par voie de placement privé, à

l’émission de parts et d’obligations et d’autres titres représentatifs d’emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter
des fonds, y compris ceux résultant des emprunts, convertibles ou non, et/ou des émissions d’obligations, à ses filiales,
sociétés affiliées et à toute autre société. Elle peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces

116715

L

U X E M B O U R G

personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. La
Société pourra en outre gager, nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre
manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente-et-un mille euros (EUR 31.000) représenté par trente-et-une (31) actions d’une

valeur nominale de mille euros (EUR 1.000) chacune.

Les actions sont exclusivement des titres nominatifs dont les certificats peuvent être émis au choix de l’actionnaire en

certificats unitaires ou en certificats représentant deux ou plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les termes et conditions prévus par la loi.
Le capital social peut être augmenté ou réduit par une décision de l’assemblée générale des actionnaires statuant

comme en matière de modification des statuts.

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non.

Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre, pour une durée qui ne peut pas

dépasser six ans. Ils sont rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Il se réunit sur la convocation du président ou de deux administrateurs. Le conseil d’administration ne peut valablement

délibérer et statuer que si la majorité de ses membres en fonction est présente ou représentée, le mandat entre admi-
nistrateurs étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par simple lettre,

télégramme, télex ou télécopie.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix du

président est prépondérante.

Art. 8. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par le président et un membre du

conseil d’administration présent aux séances. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou
ailleurs, sont signés par le président ou par deux administrateurs.

Art. 9. Le conseil d’administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour effectuer

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social.

Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de la compétence

du conseil d’administration.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la

société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs délégués et/ou plusieurs directeurs et autres
agents mandataires, actionnaires ou non.

Le conseil peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous signatures privées.

Art. 11. La société est engagée par la signature conjointe de deux administrateurs, à moins d’une délégation spéciale

du Conseil d’Administration à un seul administrateur ou à tout autre mandataire, notamment à un directeur ou à des
fondés de pouvoir.

Art. 12. Les comptes annuels sont soumis à une révision comptable effectuée annuellement par un réviseur d’entre-

prises indépendant choisi sur une liste agréée par le commissariat aux assurances.

Le réviseur indépendant a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations de la société. Il peut

prendre connaissance sans déplacement des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de toutes
les écritures de la société.

Art. 13. L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs

les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Art. 14. L’assemblée statutaire se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les convocations, le

dernier jeudi du mois de novembre à 11h00. Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant
à la même heure.

Le conseil d’administration fixera les conditions requises pour prendre part aux assemblées générales.
Les assemblées générales, même l’assemblée générale annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que se

produiront des circonstances de force majeure.

Chaque action donne droit à une voix.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

116716

L

U X E M B O U R G

L’assemblée  générale  peut  allouer  aux  administrateurs  et  réviseurs  indépendants  une  indemnité  ou  rémunération

annuelle fixe ou variable, à passer par les frais généraux.

Art. 15. Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance

de l’ordre du jour soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.

Art. 16. L’année sociale commence le premier juillet de chaque année et se termine le trente juin de l’année suivante.

Art. 17. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent (5 %) à la formation ou à l’alimentation du fonds

de réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix
pour cent (10 %) du capital social.

L’assemblée générale décide souverainement de l’affectation du solde. Les dividendes éventuellement attribués sont

payés aux endroits et aux époques déterminés par le conseil d’administration. L’assemblée générale peut autoriser le
conseil d’administration à payer les dividendes en toute autre monnaie que celle dans laquelle le bilan est dressé et à
déterminer le taux de conversion du dividende dans la monnaie du paiement effectif. Aussi longtemps que la société
détient des propres titres rachetés en portefeuille, ces titres sont dépouillés de leur droit de vote et de leur droit aux
dividendes.

Art. 18. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi du10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que

modifiée, le conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 19. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale votant dans les conditions

de présence et de majorité prévues par la loi.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 20. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales ainsi que les modifications ultérieures,

trouvera son application partout où il n’est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente juin 2015.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2015.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, la comparante, D.R.C. S.A., prénommée, représentée comme dit ci-

dessus, déclare souscrire les trente-et-une (31) actions constituant l’intégralité du capital social.

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la

somme de trente-et-un mille euros (EUR 31.000) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la nouvelle société,
ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales telle que modifiée ont été remplies.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est estimé à mille cinq cents euros.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

L’actionnaire, prénommée, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoquée,

s’est constituée en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que cette assemblée était valablement constituée, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3).
2. Sont nommés administrateurs:
a) La société anonyme «LP INVEST NV», ayant son siège social Bospleinlaan 1, B-1000 Bruxelles, ayant comme re-

présentant permanent Monsieur Philippe Moortgat, avec adresse professionnelle au 58, Breendonkdorp,B-2870 Puurs
(Belgique)

b) La société anonyme «LEMA», ayant son siège social Nelemeersstraat 57, B-9830 Sint-Martens-Latem, ayant comme

représentant permanent Monsieur Michel Moortgat, avec adresse professionnelle au 58, Breendonkdorp, B-2870 Puurs
(Belgique);

c) La société anonyme la société «Risk &amp; Reinsurance Solutions SA» en abrégé «2RS», domiciliée au 23 Avenue Mon-

terey, L-2163 Luxembourg, ayant comme représentant permanent Monsieur Gérard Dardenne avec adresse profession-
nelle au 23 Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,

116717

L

U X E M B O U R G

pour une période qui viendra à échéance lors de l’assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice se

terminant le trente juin 2019.

La Société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs.
3. Le siège social est fixé au 2, Am Hock, L-9991 Weiswampach.
4. Est nommée réviseur indépendant:
VPC Luxembourg, société à responsabilité limitée, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg

sous le numéro B 172513, ayant son siège social au 4a, Op der Haart, L-9999 Wemperhardt,

pour une période de un an qui viendra à échéance lors de l’assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice

se terminant le 30 juin 2015.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec

le notaire.

Signé: C. PEIFFER, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 4 juillet 2014. Relation: EAC/2014/9323. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur ff.

 (signé): Monique HALSDORF.

Référence de publication: 2014100963/163.
(140120844) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

Tilia Investments, Société Anonyme.

Siège social: L-8308 Capellen, 89E, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 169.486.

L'an deux mille quatorze, le vingt juin.
Par devant Maître Anja HOLTZ, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette,

A comparu

la société anonyme «TILIA Investments», constituée suivant acte reçu par Maître Anja HOLTZ, notaire alors de ré-

sidence à Wiltz en date du 24 mai 2012, publiée au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro
1763 du 13 juillet 2012, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 169.486;

Pour les besoins des présentes la comparante est représentée par l'associé unique, la société anonyme «SHAREX»,

constituée suivant acte reçu par Maître Anja HOLTZ, notaire alors de résidence à Wiltz en date du 02 février 2012,
publiée au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 784 du 24 mars 2012 et inscrite au Registre
du commerce et des sociétés Luxembourg sous le numéro B 166.882, elle-même représentée par son gérant Monsieur
Etienne CEULEMANS, résidant professionnellement au 89e Rue Pafebruch à L-8308 CAPELLEN, ce dernier représenté
par Madame Sabrina BURTAIRE, secrétaire de notaire, demeurant à Stiring Wendel, France, aux termes d'une procuration
sous seing privée, paraphée ne varietur et annexée à la présente minute.

La comparante expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour:

<i>Ordre du jour

1. Conversion des cent (100) actions ordinaires de la Société en trente et un mille (31.000) actions ordinaires, sans

augmentation de capital, mais par modification du pair comptable des actions;

2. Création d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) par action de la Société, de sorte que le capital social de la

Société soit représenté par trente et un mille (31.000) actions ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune,
et une valeur nominale totale de trente et un mille euros (EUR 31.000,-).;

3. Création de classes d'actions de la Société, soit
les actions de classe A (les Actions A),
les actions de classe B (les Actions B),
les actions de classe C (les Actions C),
les actions de classe D (les Actions D),
les actions de classe E (les Actions E),
les actions de classe F (les Actions F),
les actions de classe G (les Actions G),
les actions de classe H (les Actions H),
les actions de classe I (les Actions I),
les actions de classe J (les Actions J),

116718

L

U X E M B O U R G

toutes sous forme nominative et ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, qui auront les droits et

caractéristiques tels qu'exposés dans les statuts de la Société qui vont faire l'objet de modifications au point 8 de cet
ordre du jour;

4. Conversion des trente et un mille (31.000) actions ordinaires de la Société en trente et un mille (31.000) Actions

A;

5. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de neuf cents euros (EUR 900,-), afin de porter son capital

social de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,-), à un montant de trente et un mille neuf cents
euros (EUR 31.900,-), par voie d'émission de:

cent (100) Actions B,
cent (100) Actions C,
cent (100) Actions D,
cent (100) Actions E,
cent (100) Actions F,
cent (100) Actions G,
cent (100) Actions H,
cent (100) Actions I,
cent (100) Actions J,
toutes sous forme nominative et ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune;
6. Souscription aux nouvelles actions et libération;
7. Modification des articles 5 et 20 des statuts de la Société;
8. Modification du registre des actionnaires de la Société afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus avec pouvoir

et autorité donnés à tout employé et/ou gérant de la Société, chacun agissant individuellement, afin de procéder pour le
compte de la Société à l'inscription des actions nouvellement émises et à la mise à jour des inscriptions existantes dans
le registre des actionnaires de la Société;

9. Divers.
L'associé unique prend les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associé unique décide de convertir les cent (100) actions ordinaires existantes de la Société en trente et un mille

(31.000) actions ordinaires, sans augmentation de capital, mais par modification du pair comptable des actions.

Cette décision prenant tous ses effets à la date du 26 décembre 2013.
A cette fin, l'associé unique fait état de la libération intégrale du capital social avant augmentation au 24 décembre

2013. Une copie de la minute du conseil d'administration du 24 décembre 2013 paraphé ne varietur restera annexée à
la présente minute.

<i>Deuxième résolution

L'associé unique décide de créer une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) par action de la Société, de sorte que le

capital social de la Société soit représenté par trente et un mille (31.000) actions ayant une valeur nominale de un euro
(EUR 1,-) chacune, et une valeur nominale totale de trente et un mille euros (EUR 31.000,-).

Cette décision prenant tous ses effets à la date du 26 décembre 2013.

<i>Troisième résolution

L'associé unique décide de créer des classes d'actions de la Société, soit:
- les actions de classe A (les Actions A),
- les actions de classe B (les Actions B),
- les actions de classe C (les Actions C),
- les actions de classe D (les Actions D),
- les actions de classe E (les Actions E),
- les actions de classe F (les Actions F),
- les actions de classe G (les Actions G),
- les actions de classe H (les Actions H),
- les actions de classe I (les Actions I) et
- les actions de classe J (les Actions J),
toutes sous forme nominative et ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, qui auront les droits et

caractéristiques tels qu'exposés à l'article 5 dans les Statuts de la Société tels que modifiés suivant les résolutions ci-
dessous.

116719

L

U X E M B O U R G

Cette décision prenant tous ses effets à la date du 26 décembre 2013.

<i>Quatrième résolution

L'associé unique décide de convertir les trente et un mille (31.000) actions ordinaires de la Société en trente et un

mille (31.000) Actions A.

<i>Cinquième résolution

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de neuf cents euros (EUR 900,-), afin de

porter son capital social de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,-), à un montant de trente et un
mille neuf cents euros (EUR 31.900,-), par voie d'émission de:

- cent (100) Actions B,
- cent (100) Actions C,
- cent (100) Actions D,
- cent (100) Actions E,
- cent (100) Actions F,
- cent (100) Actions G,
- cent (100) Actions H,
- cent (100) Actions I,
- cent (100) Actions J,
toutes sous forme nominative et ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune.

<i>Sixième résolution

<i>Souscription - Libération

La société «SHAREX» Sàrl représentée par son gérant Monsieur Etienne CEULEMANS, déclare souscrire à cent (100)

Actions B, cent (100) Actions C, cent (100) Actions D, cent (100) Actions E, cent (100) Actions F, cent (100) Actions G,
cent (100) Actions H, cent (100) Actions I, cent (100) Actions J, d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, et
les libérer intégralement par un versement en espèce, de sorte que la somme de neuf cents euros (900 EUR) se trouve
dès à présent à la libre disposition de la société, tel qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate ex-
pressément.

<i>Septième résolution

L'associé unique décide de reformuler les articles 5 et 20 des Statuts comme suit:

« Art. 5.
5.1. Définitions:
«Montant Disponible» signifie le montant total des bénéfices nets de la Société (en ce compris les bénéfices reportés),

dans la mesure où les actionnaires auront eu droit à des distributions de dividende selon l'Art. 20 des Statuts, augmenté
par toute prime d'émission librement distribuable et autres réserves librement distribuables et (ii) selon les cas, par le
montant de la réduction du capital social et de la réserve légale en relation avec la classe d'Actions devant être annulée,
mais réduit par (i) toute perte (en ce compris les pertes reportées) et toutes sommes devant être mises en réserve(s)
en vertu des exigences de la Loi ou des Statuts, chaque fois comme indiqué dans les Comptes Intérimaires concernés
(sans, pour éviter tout doute, un comptage double), de sorte que:

AA = (NP + P+ CR) - (L + LR)
Où:
AA= Montant Disponible
NP = bénéfices nets (y compris les bénéfices reportés)
P = toute prime d'émission librement distribuable et autres réserves librement distribuables
CR = le montant de la réduction du capital social et de la réserve légale en relation avec la classe d'Actions devant

être annulée

L = pertes (y compris les pertes reportées)
LR = toutes sommes devant être mises en réserve(s) en vertu des exigences de la Loi ou des Statuts.
«Valeur d'Annulation par Action»
signifie le montant déterminé en vertu de l'article 5.10 ci-dessous.
«Date des Comptes Intérimaires»
signifie la date ne précédant pas de plus de quinze (15) jours la date du rachat et de l'annulation de la Classe d'Actions

concernée.

«Comptes intérimaires»

116720

L

U X E M B O U R G

signifie les comptes intérimaires de la Société au moment de la Date des Comptes Intérimaires concernée «Montant

d'Annulation Total»

signifie le montant déterminé en vertu de l'article 5.11. ci-dessous.
5.2. Le capital social de la Société est fixé à trente et un mille neuf cents euros (EUR 31.900,-), représenté par trente

et un mille (31.000) actions de classe A (en cas de pluralité, les Actions A, et individuellement, une Action A),

cent (100) actions de classe B (en cas de pluralité, les Actions B, et individuellement, une Action B),
cent (100) actions de classe C (en cas de pluralité, les Actions C, et individuellement, une Action C),
cent (100) actions de classe D (en cas de pluralité, les Actions D, et individuellement, une Action D),
cent (100) actions de classe E (en cas de pluralité, les Actions E,et individuellement, une Action E),
cent (100) actions de classe F (en cas de pluralité, les Actions F, et individuellement, une Action F),
cent (100) actions de classe G (en cas de pluralité, les Actions G, et individuellement, une Action G),
cent (100) actions de classe H (en cas de pluralité, les Actions H, et individuellement, une Action H),
cent (100) actions de classe I (en cas de pluralité, les Actions I, et individuellement, une Action I), et
cent (100) actions de classe J (en cas de pluralité, les Actions J, et individuellement, une Action J),
chaque action ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) (collectivement, les Actions, et individuellement, une

Action), qui donneront le droit de participer aux bénéfices réalisés par la Société selon les modalités indiquées ci-après.

5.3. Les actions de chaque classe d'actions seront collectivement, et indépendamment de leur classe, désignées comme

les Actions et individuellement et indépendamment de leur classe comme une Action. Les détenteurs des Actions sont
collectivement désignés comme les Actionnaires.

5.4. Chaque Action donne droit à un vote.
5.5. En supplément au capital social de la Société, un compte de prime d'émission peut être créé, sur lequel toute

prime d'émission payée sur toute Action est transférée. Toute prime d'émission payée lors de la souscription de toute
Action d'une classe spécifique lors de leur émission sera affectée à la totalité du capital social indépendamment de la classe
d'Action qui est souscrite.

5.6. Toutes les Actions auront des droits identiques, sauf disposition contraire prévue dans les présents Statuts.
5.7. Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution de l'Assemblée Générale adoptée

selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

5.8. Le capital de la Société peut être réduit par l'annulation d'Actions en ce compris par l'annulation d'une ou de

plusieurs classes d'Actions dans leur intégralité par le rachat et l'annulation de la totalité des Actions émises dans cette
classe ou ces classes. En cas de rachats et d'annulations de classes d'Actions ces annulations et rachats d'Actions seront
effectués dans l'ordre alphabétique inverse (en commençant par la classe J).

5.9. En cas d'une réduction du capital social par le rachat et l'annulation d'une classe d'Actions (dans l'ordre prévu à

l'article 5.8), cette classe donne droit aux détenteurs d'Actions de cette classe, au prorata de leur détention dans cette
classe, au Montant Disponible (avec limitation cependant au Montant d'Annulation Total tel que déterminé par l'Assemblée
Générale), et les détenteurs d'Actions de la classe rachetée et annulée recevront, de la part de la Société, un montant
égal à la Valeur d'Annulation par Action pour chaque Action de la classe en question détenue par eux et annulée.

5.10. La Valeur d'Annulation par Action sera calculée en divisant le Montant Total d'Annulation par le nombre d'Actions

émises dans la classe qui sera rachetée et annulée.

5.11. Le Montant d'Annulation Total sera un montant déterminé par le Conseil et approuvé par l'Assemblée Générale

sur base des Comptes Intérimaires en question. Le Montant d'Annulation Total pour chacune des classes J, I, H, G, F, E,
D, C, B et A sera le Montant Disponible au moment de l'annulation de la classe en question, sauf décision contraire de
l'Assemblée Générale à condition toutefois que le Montant d'Annulation Total ne soit jamais plus élevé que ce Montant
Disponible.

5.12. Lors du rachat et de l'annulation des Actions de la classe en question, la Valeur d'Annulation par Action telle que

déterminée deviendra échue et exigible par la Société.

Art. 20. Sur les bénéfices nets de la société, il est prélevé cinq pour cent pour la formation d'un fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve atteindra le dixième du capital social
souscrit de la société.

Sur recommandation du conseil d'administration ou de l'administrateur unique l'assemblée générale des actionnaires

décide de l'affectation des bénéfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un ou
plusieurs comptes de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau à la prochaine année fiscale ou de le distribuer
aux actionnaires comme dividendes.

Le conseil d'administration ou l'administrateur unique peuvent procéder à un versement d'acomptes sur dividendes

dans les conditions fixées par la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date du paiement de ces acomptes.

Dans le cas d'une déclaration de dividende, ce dividende sera affecté et versé comme suit:
- un montant égal à 0,25% de la valeur nominale de chaque Action sera distribué de façon égale à l'ensemble des

actionnaires proportionnellement à leurs Actions indépendamment de la classe, puis:

116721

L

U X E M B O U R G

- le solde du montant total distribué sera affecté intégralement aux détenteurs de la dernière classe d'Actions dans

l'ordre alphabétique inverse (soit les Actions J en premier, ensuite s'il n'y a pas d'Actions J, les Actions I et ainsi de suite
jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des Actions A).»

Cette décision prenant tous ses effets à la date du 26 décembre 2013.

<i>Huitième résolution

L'associé unique décide de modifier le registre des actionnaires de la Société afin d'y faire figurer les modifications ci-

dessus, avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant et tout employé de la Société, chacun agissant individuellement,
afin de procéder pour le compte de la Société à l'inscription des actions nouvellement émises et à la mise à jour des
inscriptions existantes dans le registre des actionnaires de la Société.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à charge à raison des présentes,

s'élèvent approximativement à la somme de 1.000,- EUR.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante connue du notaire instrumentant par dénomination,

siège et représentation elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: S. Burtaire, Anja Holtz.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 juin 2014 - EAC/2014/8624 - Reçu soixante-quinze euros = 75 €.-

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux parties pour servir à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 27 juin 2014.

Référence de publication: 2014101672/222.
(140120826) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

Aristotle S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulles.

R.C.S. Luxembourg B 188.573.

STATUTES

In the year two thousand fourteen.
On the eleventh day of July.
Before us Me Cosita DELVAUX, notary residing in Redange-sur-Attert, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Salamanca Group Trust (Switzerland) SA, having its registered office at 3, Place des Bergues, CH-1211 Geneva 1,

registered  with  the  “Registre  du  commerce  de  Génève”  under  number  CHE-100.853.925,  acting  as  Trustee  of  The
Beguteu Trust,

duly represented by Mr Luc HANSEN, “licencié en administration des affaires”, with professional address at 2, avenue

Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal, Said proxy, signed "ne varietur" by
the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated above, has requested the undersigned notary to draw up the following

articles of a joint stock company to be incorporated.

Name - Registered office - Duration - Object - Capital

Art. 1. A joint stock company is herewith formed under the name of Aristotle S.A..

Art. 2. The registered office is established in Luxembourg-City.
The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand-Duchy of Luxem-

bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office

of the company has been determined by contract with third parties, the registered office may be transferred to any other
place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors. The registered office
may be transferred to any other municipality of the Grand-Duchy by a decision of the general meeting.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

116722

L

U X E M B O U R G

Art. 4. The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the taking

of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control
and the development of such participating interests.

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of

a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents.

The company may borrow in any form whatever. The company may grant to the companies of the group or to its

shareholders, any support, loans, advances or guarantees, within the limits of the law of August 10, 1915.

The company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly

or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.

Art. 5. The share capital of the Company is fixed at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) represented by thirty-

one thousand (31,000) shares having a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, divided as follows into ten (10) classes
of shares:

1. Three thousand one hundred (3,100) shares of Class A, the “Class A shares”;
2. Three thousand one hundred (3,100) shares of Class B, the “Class B shares”;
3. Three thousand one hundred (3,100) shares of Class C, the “Class C shares”;
4. Three thousand one hundred (3,100) shares of Class D, the “Class D shares”;
5. Three thousand one hundred (3,100) shares of Class E, the “Class E shares”;
6. Three thousand one hundred (3,100) shares of Class F, the “Class F shares”;
7. Three thousand one hundred (3,100) shares of Class G, the “Class G shares”;
8. Three thousand one hundred (3,100) shares of Class H, the “Class H shares”;
9. Three thousand one hundred (3,100) shares of Class I, the “Class I shares”;
10. Three thousand one hundred (3,100) shares of Class J, the “Class J shares”.

Board of directors and statutory auditors

Art. 6. The company is administered by a board of not less than three members, the exact number being determined

by the general meeting.

If it has been established at a general meeting of shareholders that the company has a single shareholder, the board of

directors can be made up by 1 (one) member until the ordinary general meeting following the establishment of the
existence of more than one shareholder.

The directors do not need to be shareholders. They are elected by the general meeting for a term which may not

exceed 6 (six) years and can be dismissed at any time by the general meeting.

If the office of a director elected by the general meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may

provisionally fill the vacancy. In this case, the next general meeting will proceed to the final election.

Art. 7. The board of directors chooses among its members a chairman. If the chairman is unable to be present, his

place will be taken by one of the directors present at the meeting designated to that effect by the board.

The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.
The board of directors can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or repre-

sented, proxies between directors being permitted. A director can only represent one of his colleagues.

The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, fax, video conference or conference call in

the forms foreseen by the law.

Written resolutions approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the board

of directors' meetings.

Art. 8. Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes cast and have to be voted by at least one

A signatory director and by one B signatory director. In case of an equality of votes, the chairman has a casting vote.

Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at the

debates.

Copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.

Art. 10. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition

in the company's interest. All powers not expressly reserved to the general meeting by the law of August 10, 1915, as
subsequently modified, or by the present Articles of Incorporation of the company, fall within the competence of the
board of directors.

116723

L

U X E M B O U R G

Art. 11. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members

of the board or to third persons who need not be shareholders.

Art. 12. Towards third parties, the company is in all circumstances committed either by the joint signatures of one A

and one B signatory director or by the individual signature of the delegate of the board acting within the limits of his
powers. In its current relations with the public administration, the company is validly represented by one director, whose
signature legally commits the company.

Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed by

the general meeting, which determines their number and their remuneration, and who can be dismissed at any time.

The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting for a period not exceeding six

years.

However, if so required by law, or if the company decides to remove the institution of the statutory auditor, the audit

of the annual accounts shall be made by one or several “réviseurs d’entreprises agréés”, appointed or reelected by the
general meeting.

General meeting

Art. 14. In the case of a sole shareholder, the sole shareholder assumes all powers conferred to the general meeting

of shareholders and takes the decisions in writing. In these Articles, a reference to decisions taken or powers exercised
by the general meeting shall be a reference to decisions taken or powers exercised by the sole shareholder as long as
the company has only one shareholder.

In the case of a plurality of shareholders, the general meeting represents the whole body of shareholders. It has the

most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the company.

The convening notices are made in the form and delays prescribed by law.

Art. 15. The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in the

convening notice on the second Tuesday of the month of May, at 11:00 o'clock.

If such day is a holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Art. 16. The board of directors or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting. It must be convened

at the written request of shareholders representing 10% of the company's share capital.

Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote.
The company will recognise only one holder for each share; in case a share is held by more than one person, the

company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed
as sole owner, in relation to the company.

Business year - Distribution of profits

Art. 18. The business year begins on first January and ends on thirty-first December of each year.
The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.
It submits these documents with a report of the company's activities to the statutory auditor(s) at least one month

before the statutory general meeting.

Art. 19. At least 5% of the net profit for the financial year has to be allocated to the legal reserve fund. Such contribution

will cease to be compulsory when the reserve fund reaches 10% of the subscribed capital.

The remaining balance of the available profits may be distributed to the shareholders in the following order of priority:
- The holders of Class A shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an

amount of zero point one per cent (0.1%) of the nominal value of the Class A shares, then,

- the holders of Class B shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount

of zero point two per cent (0.2%) of the nominal value of the Class B shares, then,

- the holders of Class C shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount

of zero point three per cent (0.3%) of the nominal value of the Class C shares, then,

- the holders of Class D shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount

of zero point four per cent (0.4%) of the nominal value of the Class D shares, then,

- the holders of Class E shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount

of zero point five per cent (0.5%) of the nominal value of the Class E shares, then,

- the holders of Class F shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount

of zero point six per cent (0.6%) of the nominal value of the Class F shares, then,

- the holders of Class G shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount

of zero point seven per cent (0.7%) of the nominal value of the Class G shares, then,

- the holders of Class H shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount

of zero point eight per cent (0.8%) of the nominal value of the Class H shares, then,

116724

L

U X E M B O U R G

- the holders of Class I shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount

of zero point nine per cent (0.9%) of the nominal value of the Class I shares, then,

- the holders of Class J shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount

being the higher of (i) one per cent (1%) of the nominal value of the Class J shares or (ii) all the remainder of the net
profits and of the available reserves derived from retained earnings (once all distributions on the other classes of shares
have been made) to be distributed among the holders of Class J shares, based on their respective shareholding in the
Class J shares.

Should no Class J shares be in issue or should all the Class J shares have been cancelled following their repurchase or

otherwise at the time of the relevant distribution, the holders of shares forming the then last outstanding class of shares,
in reverse alphabetical order, shall be entitled to receive the higher of (i) its respective percentage, as indicated in this
article, or (ii) all the remainder of the net profits and of the available reserves derived from retained earnings (once all
distributions on the other classes of shares have been made), to be distributed among its holders and based on their
respective shareholding in the class of shares concerned. For the avoidance of doubt, such provision is applicable to all
the classes of shares which are still in issue at the time of the relevant distribution.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for the

amendment of the Articles of Incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical

persons, appointed by the general meeting which will specify their powers and remuneration.

General disposition

Art. 21. The law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently amended shall apply in so far as these

Articles of Incorporation do not provide for the contrary.

<i>Transitory dispositions

The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on 31 December 2014.
The first annual general meeting shall be held in 2015.
The first directors and the first auditor are elected by the extraordinary general shareholders' meeting that shall take

place immediately after the incorporation of the company.

By deviation from article 7 of the Articles of Incorporation, the first chairman of the board of directors is designated

by the extraordinary general meeting that designates the first board of directors of the company.

<i>Subscription and payment

The thirty-one thousand (31,000) shares have been entirely subscribed by the sole shareholder, Salamanca Group

Trust  (Switzerland)  SA,  having  its  registered  office  at  3,  Place  des  Bergues,  CH-1211  Geneva  1,  registered  with  the
“Registre du commerce de Génève” under number CHE-100.853.925, acting as Trustee of The Beguteu Trust.

All the shares have been entirely paid up in cash, so that the company has now at its disposal the sum of thirty-one

thousand Euro (EUR 31,000) as was certified to the notary executing this deed.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in article 26 of the law of August 10, 1915 on

Commercial Companies as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Expenses

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its incorporation is approximately fixed at

EUR 1,300.-.

<i>Resolutions of the sole shareholder

The sole shareholder, prenamed, represented as mentioned above, representing the whole of the share capital, passed

the following resolutions:

<i>First resolution

The number of directors is fixed at three.
The following have been elected as directors, their mandate expiring at the general meeting which will be called to

deliberate on the financial statements of the first business year:

<i>A signatory director:

1. Mrs Natacha ONAWELHO-LOREN, lawyer, born on 7 January 1971 in Kampala, Uganda, residing at 3, rue Chausse

Coq, CH1204 Geneva,

116725

L

U X E M B O U R G

<i>B signatory director(s):

2. Mr Luc HANSEN, “licencié en administration des affaires”, born on 8 June 1969 in Luxembourg, residing profes-

sionally at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,

3. Mr Philippe PONSARD, “ingénieur commercial”, born on 16 March 1967 in Arlon, Belgium, residing professionally

at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Mr Luc HANSEN has been elected as chairman of the board of directors.

<i>Second resolution

The following has been appointed as statutory auditor, its mandate expiring at the general meeting which will be called

to deliberate on the financial statements of the first business year: AUDIEX S.A., having its registered office in L-1911
Luxembourg, 9, rue du Laboratoire, R.C.S. Luxembourg B 65469.

<i>Third resolution

The company's registered office is located at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read and translated into the language of the proxy holder of the appearing person, known

to the notary by his surname, first name, civil status and residence, signed together with Us, the notary, the present
original deed.

Folgt die Deutsche Fassung des Vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendvierzehn.
Den elften Juli.
Vor uns Notar Cosita DELVAUX, mit Amtssitz zu Redange-sur-Attert, Großherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

Salamanca Group Trust (Switzerland) SA, mit Sitz in 3, Place des Bergues, CH-1211 Genf 1, eingetragen im “Registre

du commerce de Génève” unter Nummer CHE-100.853.925, handelnd als Trustee von The Beguteu Trust,

hier vertreten durch Herrn Luc HANSEN, „licencié en administration des affaires“, mit beruflicher Anschrift in L-1653

Luxemburg, 2, avenue Charles de Gaulle, auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht, Die oben aufgeführte Vollmacht
wird, nachdem sie durch den Vollmachtnehmer und den unterzeichneten Notar "ne varietur" gegengezeichnet wurde,
zusammen mit den Gesellschaftssatzungen zur Einregistrierung vorgelegt.

Welche Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzungen einer zu gründ-

enden Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden.

Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital

Art. 1. Es wird eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung Aristotle S.A. gegründet.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Filialen und Tochtergesellschaften, Agen-

turen und Büros sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Unbeschadet der Regeln des allgemeinen Rechtes betreffend die Kündigung von Verträgen, falls der Gesellschaftssitz

auf Grund eines Vertrages mit Drittpersonen festgesetzt wurde, kann, durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates,
der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der Gemeinde Luxemburg verlegt werden. Der Gesellschafts-
sitz kann durch Beschluss der Generalversammlung an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum verlegt werden.

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer errichtet.

Art. 4. Die Gesellschaft hat zum Zweck, alle Operationen, welche direkt oder indirekt zum Erwerb von Beteiligungen

unter jedweder Form an jedweden Unternehmen führen, sowie die Verwaltung, Führung, Kontrolle und Verwertung
dieser Beteiligungen.

Sie kann ihre Aktiva für die Schaffung, Verwaltung, Entwicklung, Verwertung und Liquidation eines Portfolios verwen-

den, das sich aus allen Arten von Wertpapieren und Patenten zusammensetzen kann. Sie kann sich an der Gründung,
Entwicklung und Kontrolle jedweden Unternehmens beteiligen, sowie am Erwerb von Wertpapieren und Patenten durch
Einlagen,  Zeichnung,  Festübernahme,  Kaufsoption  oder  auf  jede  andere  Art  und  Weise.  Die  Gesellschaft  kann  diese
Wertpapiere durch Verkauf, Übertragung, Austausch oder anderweitig realisieren und diese Wertpapiere und Patente
verwerten.

Die Gesellschaft kann in jedweder Form Geld aufnehmen. Sie kann, im Rahmen des Gesetzes vom 10. August 1915,

an verbundene Gesellschaften oder an Gesellschafter jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschüsse oder Garantien
gewähren.

Die Gesellschaft wird alle Maßnahmen zur Währung ihrer Rechte ergreifen und jede Art von Geschäften abschließen,

die mit ihrem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt verbunden sind oder diesen fördern.

116726

L

U X E M B O U R G

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreissigtausend Euro (EUR 31.000,-) eingeteilt in einunddreissigtausend

(31.000) Aktien mit einem Nennwert von ein Euro (EUR 1.-) pro Aktie, fest in zehn (10) Aktienklassen unterteilt, wie
folgt:

1. Dreitausendeinhundert (3.100) Aktien der Klasse A, die "Klasse A Aktien";
2. Dreitausendeinhundert (3.100) Aktien der Klasse B, die "Klasse B Aktien";
3. Dreitausendeinhundert (3.100) Aktien der Klasse C, die "Klasse C Aktien";
4. Dreitausendeinhundert (3.100) Aktien der Klasse D, die "Klasse D Aktien";
5. Dreitausendeinhundert (3.100) Aktien der Klasse E, die "Klasse E Aktien";
6. Dreitausendeinhundert (3.100) Aktien der Klasse F, die "Klasse F Aktien";
7. Dreitausendeinhundert (3.100) Aktien der Klasse G, die "Klasse G Aktien";
8. Dreitausendeinhundert (3.100) Aktien der Klasse H, die "Klasse H Aktien";
9. Dreitausendeinhundert (3.100) Aktien der Klasse I, die "Klasse I Aktien";
10. Dreitausendeinhundert (3.100) Aktien der Klasse J, die "Klasse J Aktien".

Verwaltung - Überwachung

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht. Die

Generalversammlung wird die genaue Zahl die Verwaltungsratsmitglieder festsetzen.

Wenn eine Generalversammlung festgestellt hat, dass ein alleiniger Gesellschafter alle Aktien besitzt, kann der Ver-

waltungsrat nur aus einem Mitglied bis zur nächsten Generalversammlung nach Feststellung der Vielzahl von Aktionären
bestehen.

Die Verwaltungsratsmitglieder müssen keine Aktionäre sein. Sie werden von der Generalversammlung für eine Dauer

gewählt, die nicht 6 (sechs) Jahre überschreiten darf. Sie können von der Generalversammlung jederzeit abberufen wer-
den.

Wird die Stelle eines von der Generalversammlung bestellten Verwaltungsratsmitgliedes frei, können die so ernannten

verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder, das frei gewordene Amt vorläufig besetzen. In diesem Fall erfolgt die endgültige
Wahl durch die nächste Generalversammlung.

Art. 7. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Im Falle der Verhinderung des Vorsit-

zenden übernimmt ein vom Verwaltungsrat bestimmtes Mitglied dessen Aufgabe.

Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei

ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten kann.

Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stimme zu den Tagesordnungspunkten per Brief, Faksimile, Video- oder

Telefonkonferenz in der vom Gesetz vorgesehen Form abgeben.

Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist ge-

nauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.

Art. 8. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen, wovon eine Unter-

schrift der Kategorie A und eine Unterschrift der Kategorie B angehören muss.

Art. 9. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern

unterschrieben.

Die Beglaubigung von Kopien oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevollmäch-

tigten.

Art. 10. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und

die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten. Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch
das Gesetz vom 10. August 1915 und durch die vorliegende Satzung der Generalversammlung vorbehalten ist.

Art. 11. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Aktionäre sein müssen, seine Befug-

nisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen.

Art. 12. Die Gesellschaft wird nach aussen durch die gemeinsame Unterschrift von einem Verwaltungsratmitglied der

Kategorie A und einem Verwaltungsratmitglied der Kategorie B verpflichtet, oder durch die Einzelunterschrift eines im
Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden Delegierten des Verwaltungsrates. Im laufenden Verkehr mit den
Behörden wird die Gesellschaft durch die Unterschrift eines Mitgliedes des Verwaltungsrates rechtsgültig vertreten.

Art. 13. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannten Kom-

missare überwacht, welche nicht Aktionäre sein müssen, die ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt. Sie können von der
Generalversammlung jederzeit abberufen werden.

Die Dauer der Amtszeit der Kommissare wird von der Generalversammlung festgelegt. Sie kann jedoch sechs Jahre

nicht überschreiten.

116727

L

U X E M B O U R G

Sollte eine Prüfung des Jahresabschlusses gesetzlich vorgeschrieben sein oder falls die Gesellschaft entscheidet, das

Organ des Aufsichtskommissars nicht zu besetzen, so wird die Prüfung des Jahresabschlusses durch einen oder mehrere
"réviseurs d’entreprises agréés" durchgeführt, welche von der Generalversammlung bestellt oder wiedergewählt werden.

Generalversammlung

Art. 14. Wenn und so lange ein Aktionär alle Aktien besitzt, hat dieser alle Befugnisse der Generalversammlung und

fasst seine Beschlüsse schriftlich. In dieser Satzung ist jeder Verweis auf die Beschlüsse oder die Befugnisse der General-
versammlung ein Verweis auf die Beschlüsse oder die Befugnisse des alleinigen Gesellschafters, solange ein Aktionär alle
Aktien der Gesellschaft besitzt.

Im Falle einer Vielzahl von Aktionären vertritt die Generalversammlung alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden

Vollmächte, um über die Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden.

Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäß den Bestimmungen des Gesetzes.

Art. 15. Die jährliche Generalversammlung tritt in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes an dem im Einberufungs-

schreiben genannten Ort zusammen und zwar am zweiten Dienstag des Monats Mai jeden Jahres um 11:00 Uhr.

Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Arbeitstag statt.

Art. 16. Der Verwaltungsrat oder der(die) Kommissar(e) können eine außerordentliche Generalversammlung einbe-

rufen.  Sie  muss  einberufen  werden,  falls  Aktionäre,  die  mindestens  10%  des  Gesellschaftskapitals  vertreten,  einen
derartigen Antrag stellen.

Art. 17. Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme.
Die Gesellschaft wird nur einen Inhaber pro Aktie anerkennen; für den Fall, dass eine Aktie mehreren Personen gehört,

hat die Gesellschaft das Recht, die Ausübung aller Verfügungsrechte, welche dieser Aktie anhaften, zu suspendieren, und
zwar solange bis der Gesellschaft gegenüber ein einziger Eigentümer ernannt wird.

Geschäftsjahr - Gewinnverteilung

Art. 18. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember jeden Jahres.
Der Verwaltungsrat erstellt den Jahresabschluss, wie gesetzlich vorgeschrieben.
Er legt diesen, mit einem Bericht über die Geschäfte der Gesellschaft, spätestens einen Monat vor der Jahresgeneral-

versammlung, den Kommissaren zur Einsicht, vor.

Art. 19. Vom Nettogewinn des Geschäftsjahres sind mindestens 5% für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu

verwenden; diese Verpflichtung gilt solange bis die gesetzliche Rücklage 10% des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Der Saldo des Bilanzgewinnes kann in der folgenden Reihenfolge der Priorität an die Aktieninhaber verteilt werden:
- Den Aktieninhabern der Klasse A stehen Ausschüttungen für das entsprechende Jahr, in Höhe von null Komma ein

Prozent (0,1%) des Nennwertes der Aktien der Klasse A zu, und dann,

- Den Aktieninhabern der Klasse B stehen Ausschüttungen für das entsprechende Jahr, in Höhe von null Komma zwei

Prozent (0,2%) des Nennwertes der Aktien der Klasse B zu, und dann,

- Den Aktieninhabern der Klasse C stehen Ausschüttungen für das entsprechende Jahr, in Höhe von null Komma drei

Prozent (0,3%) des Nennwertes der Aktien der Klasse C zu, und dann,

- Den Aktieninhabern der Klasse D stehen Ausschüttungen für das entsprechende Jahr, in Höhe von null Komma vier

Prozent (0,4%) des Nennwertes der Aktien der Klasse D zu, und dann,

- Den Aktieninhabern der Klasse E stehen Ausschüttungen für das entsprechende Jahr, in Höhe von null Komma fünf

Prozent (0,5%) des Nennwertes der Aktien der Klasse E zu, und dann,

- Den Aktieninhabern der Klasse F stehen Ausschüttungen für das entsprechende Jahr, in Höhe von null Komma sechs

Prozent (0,6%) des Nennwertes der Aktien der Klasse F zu, und dann,

- Den Aktieninhabern der Klasse G stehen Ausschüttungen für das entsprechende Jahr, in Höhe von Nullpunkt sieben

Prozent (0,7%) des Nennwertes der Aktien der Klasse G zu, und dann,

- Den Aktieninhabern der Klasse H stehen Ausschüttungen für das entsprechende Jahr, in Höhe von Nullpunkt acht

Prozent (0,8%) des Nennwertes der Aktien der Klasse H zu, und dann,

- Den Aktieninhabern der Klasse I stehen Ausschüttungen für das entsprechende Jahr, in Höhe von Nullpunkt neuen

Prozent (0,9%) des Nennwertes der Aktien der Klasse I zu, und dann,

- Den Aktieninhabern der Klasse J stehen Ausschüttungen für das entsprechende Jahr, in Höhe des höheren zwischen

(i) ein Prozent (1 %) des Nennwertes der Aktien der Klasse J oder (ii) all die restlichen zur Verfügung stehenden Net-
togewinne  und  die  verfügbaren,  durch  Gewinnrücklagen  gespeisten  Reserven  zu  (sobald  die  Ausschüttungen  an  die
anderen Aktienklassen vorgenommen worden sind), die unter den Inhabern der Aktien der Klasse J, auf der Grundlage
ihrer jeweiligen Beteiligung an den Aktien der Klasse J verteilt wird.

Sollten, zum Zeitpunkt der Ausschüttung, keine Aktien der Klasse J mehr ausstehend sein oder sollten die Aktien der

Klasse J annulliert worden sein, nach Rückkauf oder auf andere Weise, stehen den Aktieninhabern der nächsten Aktien-
klasse, in umgekehrter alphabetischer Reihenfolge, Ausschüttungen für das entsprechende Jahr, in Höhe des höheren

116728

L

U X E M B O U R G

zwischen (i) dem entsprechendem Prozentsatz, wie in diesem Artikel beschrieben oder (ii) all die restlichen zur Verfügung
stehenden Nettogewinne und die verfügbaren, durch Gewinnrücklagen gespeisten, Reserven zu (sobald die Ausschüt-
tungen an die anderen Aktienklassen vorgenommen worden sind), die unter den Inhabern der entsprechenden Aktien-
klasse,  auf  der  Grundlage  ihrer  jeweiligen  Beteiligung  an  den  Aktien  dieser  Klasse  verteilt  wird.  Um  jeden  Zweifel
auszuschließen, betrifft die obige Anordnung alle Aktienklassen, die zum Zeitpunkt der Ausschüttung noch ausstehend
sind.

Auflösung - Liquidation

Art. 20. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den gleichen

Bedingungen gefasst werden muss wie bei Satzungsänderungen.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durch-

geführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer
Aufgaben und Vergütungen ernannt werden.

Allgemeine Bestimmung

Art. 21. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, wird auf die Bestimmungen des abgeänderten

Gesetzes vom 10. August 1915 verwiesen.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2014.
Die erste Generalversammlung findet im Jahr 2015 statt.
Die ersten Verwaltungsratsmitglieder und der erste Kommissar werden von der außerordentlichen Gesellschafter-

versammlung ernannt, die sofort nach der Gründung abgehalten wird.

In Abweichung von Artikel 7 der Satzung wird der erste Vorsitzende von der Generalversammlung gewählt, welche

den ersten Verwaltungsrat ernennt.

<i>Kapitalzeichnung

Die einunddreissigtausend (31.000) Aktien wurden durch den alleinigen Aktionär, Salamanca Group Trust (Switzerland)

SA, mit Sitz in 3, Place des Bergues, CH-1211 Genf 1, eingetragen im “Registre du commerce de Génève” unter Nummer
CHE-100.853.925, handelnd als Trustee von The Beguteu Trust, gezeichnet.

Alle Aktien wurden in bar voll eingezahlt, so dass der Betrag von einunddreissigtausend Euro (EUR 31.000) der Ge-

sellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was hiermit ausdrücklich von dem amtierenden Notar festgestellt wurde.

<i>Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaften, sowie auf die späteren Änderungen erfüllt sind.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen betragen schätzungsweise

EUR 1.300,-.

<i>Beschlüsse des Alleinigen Aktionärs

Der vorgenannte alleinige Aktionär, vertreten wie vorerwähnt, welcher das gesamte Gesellschaftskapital darstellt, hat

sofort folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Zahl der Verwaltungsmitglieder wird auf drei festgelegt.
Zu Verwaltungsratsmitgliedern bis zur Generalversammlung, die über die Bilanz des ersten Geschäftsjahres befindet,

werden ernannt:

<i>Kategorie A

1. Frau Natacha ONAWELHO-LOREN, Anwältin, geboren am 7. Januar 1971 in Kampala, Uganda, wohnhaft in 3, rue

Chausse Coq, CH-1204 Genf,

<i>Kategorie B

2. Herr Luc HANSEN, “licencié en administration des affaires”, geboren am 8. Juni 1969 in Luxemburg, mit beruflicher

Anschrift in L-1653 Luxemburg, 2, avenue Charles de Gaulle,

3. Herr Philippe PONSARD, “ingénieur commercial”, geboren am 16. März 1967 in Arlon, Belgien, mit beruflicher

Anschrift in L-1653 Luxemburg, 2, avenue Charles de Gaulle.

Herr Luc HANSEN, vorgenannt, wird zu Vorsitzender des Verwaltungsrats ernannt.

116729

L

U X E M B O U R G

<i>Zweiter Beschluss

Zum Kommissar bis zur Generalversammlung, die über die Bilanz des ersten Geschäftsjahres befindet, wird ernannt:

AUDIEX S.A., mit Sitz in L-1911 Luxemburg, 9, rue du Laboratoire, R.C.S. Luxemburg B 65469.

<i>Dritter Beschluss

Die Gesellschaft hat ihren Gesellschaftssitz in L-1653 Luxemburg, 2, avenue Charles de Gaulle.

WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten der Komparentin, dem instrumen-

tierenden Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.

Gezeichnet: L. HANSEN, C. DELVAUX.
Enregistré à Redange/Attert, le 14 juillet 2014. Relation: RED/2014/1524. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur ff.

 (signé): M. ELS.

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum

Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Redange-sur-Attert, den 14. Juli 2014.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2014102812/415.
(140121732) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2014.

G-P Latin America S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 144.619.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014095888/9.
(140114833) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2014.

Presco Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 124.417.

In the year two thousand and fourteen, on the twentieth of June.
Before Us Maître Jean SECKLER, notary residing at Junglinster, (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned;

Is held

an Extraordinary General Meeting of the sole partner of "PRESCO INVESTMENTS S.à r.l." a private limited liability

company (Société à responsabilité limitée), having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
incorporated by a deed of Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch/Alzette, on December 29, 2006, registered
with the Trade and Companies' Register of Luxembourg section B number 124.417, published in the Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations dated April 21, 2007, under number C 676. The articles of incorporation have been modified
by a deed of Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch/Alzette, on July 5, 2012, published in the Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations C number 2154 of August 30, 2012. The articles of incorporation have been modified for
the last time by a deed of Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch/Alzette of October 22, 2012, published in the
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C under number 64, dated January 10, 2013 and for the last time by a
deed of the undersigned notary on May 15, 2014, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting is presided by Mrs Cristiana VALENT, employee, with professional address in Junglinster, 3, route de

Luxembourg.

The Chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr Henri DA CRUZ, employee, with pro-

fessional address in Junglinster, 3, route de Luxembourg.

The Chairman requests the notary to act that:
i. The sole partner present or represented and the number of shares held are shown on an attendance list. That list

and proxy, signed by the appearing party and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.

ii. As appears from the attendance list, the seven hundred and fifty-two thousand eight hundred (752.800) shares of

PLN 100,- (one hundred polish zloty) each, representing the whole share capital of the company, are represented so that
the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the sole partner has been beforehand informed.

iii. The agenda of the meeting is the following:

116730

L

U X E M B O U R G

<i>Agenda

1. Decrease of the Company's subscribed share capital by an amount of PLN 29.000.000 (twenty-nine million polish

zloty), in order to decrease it from its current amount of PLN 75.280.000 (seventy-five million two hundred and eighty
thousand polish zloty) to PLN 46.280.000 (forty-six million two hundred and eighty thousand polish zloty) through the
redemption of 290.000 (two hundred and ninety thousand) Class A shares held by the sole shareholder, with a nominal
value of 100 PLN (one hundred polish zloty) each by a repayment to the sole shareholder.

2. The remaining 410.300 (four hundred and ten thousand three hundred) Class A shares will remain in Compartment

PLN.

3. Decrease of the legal reserve by an amount of PLN 2.900.000 (two million nine hundred thousand polish zloty) to

decrease it from PLN 7.528.000 (seven million five hundred and twenty-eight thousand polish zloty) to PLN 4.628.000
(four million six hundred and twenty-eight thousand polish zloty) by a repayment to the sole shareholder.

4. Amendment of Article 6 of the Articles of Incorporation further to the above resolutions.
5. Miscellaneous.
That, based on the aforementioned agenda, the general meeting took the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting resolves to decrease the company's subscribed share capital by an amount of twenty-nine million polish

zloty (PLN 29.000.000.-), in order to decrease it from its current amount of seventy-five million two hundred and eighty
thousand polish zloty (PLN PLN 75.280.000.-) to forty-six million two hundred and eighty thousand polish zloty (PLN
PLN 46.280.000.-), through the redemption of two hundred and ninety thousand (290.000) class A Shares held by the
sole shareholder, with a nominal value of one hundred polish zloty (PLN 100.-) each.

The remaining four hundred and ten thousand three hundred (410.300) Class A shares will remain in Compartment

PLN.

<i>Second resolution

The meeting resolves to decrease the legal reserve by an amount of two million nine hundred thousand polish zloty

(PLN 2,900,000.-) to decrease it from seven million five hundred and twenty-eight thousand polish zloty (PLN 7,528,000.-)
to four million six hundred and twenty-eight thousand polish zloty (PLN 4,628,000.-) by repayment to the sole share-
holder.

<i>Third resolution

The meeting decides to amend article six (6) of the articles of incorporation, in order to reflect such action, and to

give it the following wording:

Art. 6. The Company's capital is set at forty-six million two hundred and eighty thousand polish zloty (PLN 46.280.000)

represented by four hundred and sixty-two thousand eight hundred (462.800) shares, divided into four hundred and ten
thousand three hundred (410.300) class A shares and fifty-two thousand five hundred (52.500) class B shares of one
hundred polish zloty (100 PLN) each.”.

<i>"Costs

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed

are estimated at EUR 1,300.-.

The total amount of the Capital decreases is valued at EUR 7,000,000.-.
Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the mandatory

the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same mandatory, in case of
discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the mandatory, known to the notary by his surname, first name, civil status and

residence, the said mandatory signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille treize, le vingt juin.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

Se réunit

une assemblée générale extraordinaire des associés de la Société à responsabilité limitée «PRESCO INVESTMENTS

S.à r.l.» ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des

116731

L

U X E M B O U R G

Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 124.417, constituée suivant acte reçu par Maître Francis KESSELER,
notaire  de  résidence  à  Esch-sur-Alzette,  daté  du  29  décembre  2006,  publié  au  Mémorial  C,  Recueil  des  Sociétés  et
Associations en date du 21 avril 2007 sous le numéro C 676. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître
Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 5 juillet 2012, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 2154 du 30 août 2012. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu
par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 22 octobre 2012, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 64 du 10 janvier 2013.

L'assemblée est présidée par Madame Cristiana VALENT, employée, ayant son adresse professionnelle à Junglinster,

3, route de Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Henri DA CRUZ, employé,

ayant son adresse professionnelle à Junglinster, 3, route de Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:
i. L'associé unique présent ou représenté et le nombre de parts qu'il détient son renseignés sur une liste de présence.

Cette liste et la procuration, une fois signées par le comparant et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour
être enregistrées avec l'acte.

ii. Il ressort de la liste de présence que les 752.800 (sept cent cinquante-deux mille huit cents) parts sociales de PLN

100,- (cent zloty polonais) chacune, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblées
extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont
l'associé unique a été préalablement informé.

iii. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. Réduction du capital social à concurrence de vingt-neuf million zloty polonais (PLN 29.000.000,-), pour le porter de

son montant actuel de soixante-quinze million deux cent quatre-vingt mille zloty polonais (PLN 75.280.000,-) à quarante-
six millions deux cent quatre-vingt mille zloty polonais (PLN 46.280.000,-) par remboursement à l'associé unique.

2. Les quatre cent dix mille trois cents (410.300) parts sociales de catégorie A restantes resteront affectées dans le

Compartiment PLN.

3. Réduction de la réserve légale à concurrence de deux millions neuf cent mille zloty polonais (PLN 2.900.000,-) pour

la porter de son montant actuel de sept millions cinq cent vingt-huit mille zloty polonais (PLN 7.528.000,-) à quatre millions
six cent vingt-huit mille zloty polonais (PLN 4.628.000,-) par remboursement à l'associé unique.

4. Modification afférente de l'article 6 des statuts.
5. Divers

<i>Première résolution

L'assemblée décide de réduire le capital social d'un montant de vingt-neuf millions de zloty polonais (PLN 29.000.000,-),

pour  le  porter  de  son  montant  actuel  de  soixante-quinze  millions  deux  cent  quatre-vingt  mille  zloty  polonais  (PLN
75.280.000,-) à quarante-six millions deux cent quatre-vingt mille zloty polonais (PLN 46.280.000,-) par remboursement
à l'associé unique.

Les quatre cent dix mille trois cents (410.300) parts sociales de catégorie A restantes resteront affectées au Com-

partiment PLN.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de réduire la réserve légale d'un montant de deux millions neuf cent mille zloty polonais (PLN

2.900.000,-)  pour  la  porter  de  son  montant  actuel  de  sept  millions  cinq  cent  vingt-huit  mille  zloty  polonais  (PLN
7.528.000,-) à quatre millions six cent vingt-huit mille zloty polonais (PLN 4.628.000,-) par remboursement à l'associé
unique.

<i>Troisième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article six (6) des statuts afin de lui donner la teneur

suivante:

« Art. 6. Le capital social est fixé à quarante-six millions deux cent quatre-vingt mille zloty polonais (PLN 46.280.000,-),

divisé en quatre cent soixante-deux mille huit cents (462.800) parts sociales divisées en quatre cent dix mille trois cents
(410.300) parts sociales de catégorie A et cinquante-deux mille cinq cents (52.500) parts sociales de catégorie B de cent
zloty polonais (PLN 100,-) chacune.».

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève

approximativement à 1.300,- EUR.

Le montant total des réductions est évalué à 7.000.000,- EUR.

116732

L

U X E M B O U R G

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête du mandataire, les

présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française; à la requête du même mandataire et en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Cristiana VALENT, Henri DA CRUZ, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 30 juin 2014. Relation GRE/2014/2566. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2014100330/148.
(140119155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2014.

Corpus Sireo Investment Residential No. 14 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 130.419.

Im Jahre zweitausendvierzehn, am dreißigsten Tag des Monats Juni.
Vor der unterzeichnenden Notarin Maître léonie GRETHEN, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Sind erschienen:

1) CORPUS SIREO Investment Residential Holding GmbH &amp; Co. KG, eine nach deutschem Recht bestehende Kom-

manditgesellschaft mit Gesellschaftssitz in 186, Aachener Straße, D-50931 Köln, Deutschland und im Handelsregister des
Amtsgerichts  Köln  unter  der  Nummer  HRA  26442  eingetragen  durch  den  Gesellschafter  2  in  seiner  Eigenschaft  als
Komplementär handelnd (hiernach "Gesellschafter 1")

und
2)  CORPUS  SIREO  Investment  Residential  GmbH,  eine  nach  deutschem  Recht  bestehende  Gesellschaft  mit  bes-

chränkter Haftung mit Gesellschaftssitz in 186, Aachener Straße, D-50931 Köln, Deutschland und im Handelsregister des
Amtsgerichts Köln unter der Nummer HRB 66701 eingetragen (hiernach "Gesellschafter 2" und gemeinsam mit dem
Gesellschafter 1 als die "Gesellschafter" bezeichnet).

Die Gesellschafter werden infolge privatschriftlicher Vollmachten durch Herrn Peter F. Bonert, Rechtsanwalt, mit

professioneller Anschrift in 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, vertreten.

Die besagten Vollmachten werden, nachdem sie durch den Bevollmächtigten und die Notarin paraphiert und gegen-

gezeichnet worden sind, dieser Urkunde zum Zwecke der Registrierung beigefügt.

Die erschienenen Parteien erklären hiermit, dass sie die alleinigen Gesellschafter von CORPUS SIREO Investment

Residential No. 14 S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht (Société à respon-
sabilité limitée) mit Gesellschaftssitz in 4a, Rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, mit
einem Gesellschaftskapital von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), eingetragen im Luxemburger Handelsre-
gister (Registre de Commerce et des Sociétés) unter der Nummer B 130.419 (die "Gesellschaft"), sind und das gesamte
Gesellschaftskapital der Gesellschaft halten. Die Gesellschaft wurde am 1. August 2007 durch notarielle Urkunde des
Notars Maître Jean-Joseph Wagner, mit damaligem Amtssitz in Sassenheim, Großherzogtum Luxemburg, gegründet, was
im Luxemburger Amtsblatt (Mémorial C, Recueil des Associations et des Sociétés) Nummer 2027 vom 19. September
2007 veröffentlicht wurde. Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt am 30. Dezember 2013 durch notarielle Urkunde
der Notarin Maître Martine Schaeffer, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, verändert und im Lu-
xemburger Amtsblatt (Mémorial C, Recueil des Associations et des Sociétés) Nummer 937 am 11. April 2014 veröffent-
licht.

Die ordnungsgemäß vertretenen Parteien erklären, von den zu beschließenden Punkten entsprechend der Tagesord-

nung Kenntnis zu haben.

Die Tagesordnung lautet wie folgt:

<i>Tagesordnung

1) Neueinteilung des ausgegebenen Gesellschaftskapitals durch Abänderung und Reduzierung des Nennwerts eines

Gesellschaftsanteils von derzeit fünf Hundert Euro (EUR 500,-) auf einen Euro Cent (EUR 0,01), mit der Folge, dass das
Gesellschaftskapital, das derzeit aus fünfundzwanzig (25) Gesellschaftsanteilen besteht, auf eine Million zweihundertfünf-
zigtausend (1.250.000) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je einem Euro Cent (EUR 0,01) aufgeteilt wird und
dass daraufhin der Gesellschafter 1 eine Million einhundertfünfzigtausend (1.150.000) Gesellschaftsanteile und der Ge-

116733

L

U X E M B O U R G

sellschafter 2 ein hunderttausend (100.000) Gesellschaftsanteile der Gesellschaft mit einem Nennwert von je einem Euro
Cent (EUR 0,01) hält;

2) Änderung der Satzung der Gesellschaft, um den unter Punkt 1 verabschiedeten Beschluss darin widerzuspiegeln;
3) Verschiedenes.
Die wirksam vertretenen Parteien haben die unterzeichnende Notarin gebeten, folgende Beschlüsse zu beurkunden:

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafter beschließen, das ausgegebene Gesellschaftskapital neu einzuteilen, indem der Nennwert eines Ge-

sellschaftsanteils von derzeit fünfhundert Euro (EUR 500,-) auf einen Nennwert eines Gesellschaftsanteils von einem Euro
Cent (EUR 0,01) abgeändert und reduziert wird, mit der Folge, dass das Gesellschaftskapital, das derzeit aus fünfundz-
wanzig (25) Gesellschaftsanteilen besteht, auf eine Million zweihundertfünfzigtausend (1.250.000) Gesellschaftsanteile mit
einem Nennwert von je einem Euro Cent (EUR 0,01) aufgeteilt wird und dass daraufhin der Gesellschafter 1 eine Million
einhundertfünfzigtausend (1.150.000) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je einem Euro Cent (EUR 0,01) und
der Gesellschafter 2 einhunderttausend (100.000) Gesellschaftsanteile hält.

<i>Zweiter Beschluss

Die Gesellschafter beschließen, die Satzung der Gesellschaft zu ändern, um den ersten Beschluss dieser Urkunde darin

widerzuspiegeln.

Artikel 5.1 der Satzung der Gesellschaft hat demzufolge folgenden Wortlaut:

5.1. Das Gesellschaftskapital beläuft sich auf zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) und ist in eine Million

zweihundertfünfzigtausend (1.250.000) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je einem Euro Cent (EUR 0,01)
aufgeteilt."

<i>Ausgaben

Die Kosten, Ausgaben, Gebühren oder Lasten, die in irgendeiner Form der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde

erwachsen, werden auf eintausend Euro (EUR 1.000,-) veranschlagt.

Worüber die gegenwärtige notarielle Urkunde am eingangs erwähnten Datum in Luxemburg aufgenommen wurde.
Nach Vorlesung und Erklärung des Vorstehenden an den erschienenen Vertreter, der der Notarin von seinem Vor-

namen, Nachnamen, Familienstand und seiner professionellen Adresse her bekannt ist, hat dieselbe Person zusammen
mit der beurkundenden Notarin, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Bonert, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 2 juillet 2014. Relation: LAC/2014/30547. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

<i>Le Receveur ff.

 (signé): Carole FRISING.

Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Memorial C.

Luxemburg, den 10. Juli 2014.

Référence de publication: 2014100924/77.
(140120200) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

General Shale Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 118.992.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014095891/9.
(140114901) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2014.

Flint Hills Resources Financing S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 173.987.

Les comptes annuels de la société Flint Hills Resources Financing S.à r.l. au 31/12/2013 ont été déposés au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014095842/10.
(140114388) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2014.

116734

L

U X E M B O U R G

Compagnie Financière de Participations Européennes, Société Anonyme.

Siège social: L-4740 Pétange, 5, rue Prince Jean.

R.C.S. Luxembourg B 43.474.

L'an deux mille quatorze,
le trente juin.
Par devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est réunie

l’assemblée générale extraordinaire (l’«Assemblée») des actionnaires de «COMPAGNIE FINANCIERE DE PARTICI-

PATIONS EUROPEENNES» (la «Société»), une société anonyme établie et ayant son siège social au 5, rue Prince Jean,
L-4740 Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant un acte notarié dressé en date du 05 avril 1993, lequel
acte de constitution fut publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association (le «Mémorial») en 1993 sous le numéro
295 et page 14154.

Les statuts de la Société furent modifiés la dernière fois suivant acte notarié dressé par le notaire soussigné en date

du 31 mars 2014, sa publication au Mémorial fut faite, le 21 juin 2014, sous le numéro 1608 et page 77176.

La Société est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 43

474.

La séance est ouverte et est présidée par Monsieur Brendan D. KLAPP, employé privé, avec adresse professionnelle

à Belvaux, GrandDuché de Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Nadia WEYRICH, employée privée, avec adresse professionnelle à Belvaux,

Grand-Duché de Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Vincent DEMEUSE, employé privé, avec adresse professionnelle à

Pétange, Grand-Duché de Luxembourg.

Le bureau de l’Assemblée ayant ainsi été constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire

d'acter:

Les actionnaires présents ou représentés à l’Assemblée et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été

portés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires de ceux représentés,
demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Il résulte de ladite liste de présence que la présente Assemblée réunissant l’intégralité du capital social fixé à DEUX

MILLIONS CINQ CENT QUATRE-VINGT-DOUZE MILLE EUROS (2'592'000.- EUR), divisé en vingt et un mille six cents
(21'600) actions ordinaires, ayant chacune une valeur nominale de CENT VINGT EUROS (120.- EUR) est régulièrement
constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur objets portés à l’ordre du jour, qui est conçu
comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Changement de la nationalité de la Société et transfert du siège social de la Société du Grand-Duché de Luxembourg

à B-8730 Beernem, Parkstraat 2 (Belgique), décision à prendre à l’unanimité des actionnaires, conformément à l’article
67-1 (1) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Adoption par la Société de la nationalité belge,
le changement de nationalité et le transfert du siège ne donnant lieu, ni légalement, ni fiscalement à la dissolution ni à la
constitution d'une nouvelle société, le tout sous condition suspensive de l’inscription de la société au Registre des Per-
sonnes Morales à Brugge (Belgique).

2. Fixation de la nouvelle adresse du siège social transféré à B-8730 Beernem, Parkstraat 2 Belgique et adoption par

la société de la nationalité belge, sous réserve de l’acceptation du transfert de siège par les autorités compétentes en
Belgique.

3. Acceptation de la démission avec décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société avec

effet au jour de la radiation de la Société au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

4. Décision d'autoriser la SA Titeca Accountancy, n° d’entreprise 0882.371.584, ayant son siège social à B-8800 Roe-

selare (Belgique), représentée par Monsieur Fabian MISSINE, afin de représenter dorénavant la Société devant toutes les
instances administratives et fiscales en Belgique à la suite du transfert de siège et du changement de nationalité comme
dit ci-avant et en vue de l’inscription de la Société en Belgique.

5. Décision de conférer à la société «LUCOS COMPANY SERVICES S.A.», une société anonyme établie et ayant son

siège social au 5 rue Prince Jean, L-4740 Pétange (RCS Luxembourg, section B numéro 11 768), tous les pouvoirs pour
exécuter les obligations légales de la Société restant à être faites à Luxembourg et pour radier la Société au Registre de
Commerce et des Sociétés à Luxembourg, sur base d’un certificat d’inscription au Registre des Personnes Morales à
Brugge (Belgique).

6. Divers.
Après délibération, les résolutions suivantes ont été prises à l’unanimité des voix:

116735

L

U X E M B O U R G

<i>Première résolution

L’Assemblée décide de changer la nationalité de la Société et de transférer le siège social statutaire et le siège de

direction effectif de la Société du Grand-Duché de Luxembourg à B-8730 Beernem, Parkstraat 2 (Belgique), conformément
à l’article 67-1 (1) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

L’Assemblée décide d’adopter par la Société la nationalité belge, le changement de nationalité et le transfert du siège

ne donnant lieu, ni légalement, ni fiscalement à la dissolution ni à la constitution d'une nouvelle société, le tout sous
condition suspensive de l’inscription de la société au Registre des Personnes Morales à Brugge (Belgique).

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de fixer la nouvelle adresse du siège social transféré à B-8730 Beernem, Parkstraat 2, Belgique et

que la Société adopte la nationalité belge, sous réserve de l’acceptation du transfert de siège par les autorités compétentes
en Belgique.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide d’accepter la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes de la Société actuel-

lement en fonction et de leur accorder pleine et entière décharge pour l’exécution de leurs mandats respectifs avec effet
au jour de la radiation de la Société au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide d’autoriser la SA Titeca Accountancy, n° d’entreprise 0882.371.584, ayant son siège social à B-8800

Roeselare (Belgique), représentée par Monsieur Fabian MISSINE à représenter dorénavant la Société devant toutes les
instances administratives et fiscales en Belgique à la suite du transfert de siège et du changement de nationalité comme
dit ci-avant et en vue de l’inscription de la Société en Belgique.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée décide de conférer à la société «LUCOS COMPANY SERVICES S.A.», une société anonyme établie et

ayant son siège social au 5 rue Prince Jean, L-4740 Pétange (RCS Luxembourg, section B numéro 11 768), tous les pouvoirs
pour exécuter les obligations légales de la Société restant à être faites au Grand-Duché de Luxembourg et pour radier
la Société au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, sur base d’un certificat d’inscription au Registre des
Personnes Morales à Brugge (Belgique).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, le Président lève la séance.

DONT ACTE, fait et passé à Belvaux, Grand-Duché de Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu'en tête

des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: B.D. KLAPP, N. WEYRICH, V. DEMEUSE, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 01 juillet 2014. Relation: EAC/2014/9049. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2014100914/92.
(140120924) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.

Iberian Capital III, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 40.000,00.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 140.047.

Par décision du conseil de gérance de la Société, prise en date du 3 juillet 2014, il a été décidé de transférer de le siège

social de la Société du 19-21 Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, au 20, Rue de la Poste, L-2346 Luxembourg,
avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Iberian Capital III
D. Audia
<i>Manager B

Référence de publication: 2014098283/15.
(140116747) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2014.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

116736


Document Outline

AFP (Germany) IV S.à r.l.

Aida Wedo 10 S.A.

Alarane S.A.

Aristotle S.A.

Compagnie Financière de Participations Européennes

Corpus Sireo Investment Residential No. 14 S.à r.l.

Digital Services XXV (GP) S.à r.l.

DRC2 S.A.

EEE 3 S.à r.l.

EEE 5 S.à r.l.

Eltis

EPP Bois Chaland (Lux) S.à r.l.

EPP Dames de Paris (Lux) S.à r.l.

EPP Massy Ile de France (Lux) S.à r.l.

EPS Participations S.à r.l.

EQUI Specialized Asset Management S.A.

Eulerphi S.C.A. SICAF-SIF

Eurofin Capital SICAV - SIF SCA

Euro Immobiltecno Invest S.A.

Euro Leasing AG

Europa Rock S.à r.l.

European Dynamics Luxembourg S.A.

European NPL S.A.

Euroshoes S.A.

Eurosoft Project S.A.

EVPA Group S.àr.l.

Exclusive Real Estate S.A.

Executive Job S. à r.l.

Fabe S.à r.l.

Face International S.à.r.l.

Federal Express Luxembourg, Inc.

Fertifin S.A.

FFS 2 S.à r.l.

FFS 3 S.à r.l.

FIDEURO

Finbra S.A.

Flex S.A.

Flex S.A.

Flint Hills Resources Financing S.à r.l.

Flovax

FN International

Foncière de Seine S.A.

Foncier &amp; Participations S.A.

Forum TFI Investment S.à r.l.

Franchise International (Luxembourg)

FR Group Holdings S.à r.l.

Froidchapelle S.A.

Fundamentum Asset Management S.A.

Fundo de Investimento Privado - Angola S.C.A., SICAV-SIF

Funds For Good S.A.

General Shale Finance S.à r.l.

G-Finance S.à r.l.

Globec Industries

G-P Latin America S.à r.l.

Iberian Capital III

KKR International Flowers S.à r.l.

Monitchem Holdco 2 S.A.

Presco Investments S.à r.l.

Tilia Investments