logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2427

10 septembre 2014

SOMMAIRE

33 Grosvenor Place Limited . . . . . . . . . . . . .

116460

Adel-Fis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116455

Altaira Funds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116457

Andante  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116457

Auber S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116451

Bond Relative Return  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116455

Caelus Energy International Holdings S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116451

Castle Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116452

China Designer Outlet Mall S.A. . . . . . . . . .

116452

Comfintex S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116450

Cordial Arrow Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116457

DA Jupiter Lux LT Holdings S.à r.l.  . . . . . .

116483

EuroSwitch Balanced Portfolio OP  . . . . . .

116454

EuroSwitch Defensive Concepts OP  . . . . .

116454

FD immobilier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116483

Ferrero International S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

116483

Finnovation S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116494

Flaugust S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116450

Generation S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116456

Georgia-Pacific Andes S.à r.l. . . . . . . . . . . . .

116459

Gerana SICAV-SIF, S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

116482

GERES Investment S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

116456

Ginkgo No. 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116455

GLL Real Estate Selection Fund  . . . . . . . . .

116454

Goldorak Investments  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116455

Goodman Alizarin Logistics (Lux) S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116473

Goodman Peppermint Logistics (Lux) S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116473

GPIM Themis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116454

Kirchberg Asset and Investment Manage-

ment S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116473

LF Real Estate S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116454

Maricath S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116450

Montinvest International S.A.  . . . . . . . . . . .

116451

Next Real Estate Polish Retail Holdco S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116453

Olivetree Absolute Return  . . . . . . . . . . . . . .

116455

One S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116472

PBN Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116457

R.A. Investment Management S.à r.l.  . . . .

116482

Russian Mortgage Backed Securities

2006-1 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116452

Styrolution Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . .

116464

Tamata S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116456

The Archstone German Residential Fund II

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116459

UniInstitutional European Corporate

Bonds +  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116453

UniInstitutional European Corporate

Bonds +  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116453

UniKonzept: Portfolio  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116453

UniKonzept: Portfolio  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116453

Viva Gestions Immobilières S.A. . . . . . . . . .

116496

White Star S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116495

Work Inside Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . .

116496

116449

L

U X E M B O U R G

Maricath S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 7A, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 182.849.

Messieurs, Mesdames, les actionnaires, nous avons l'honneur de vous informer que vous êtes convoqués, le 26 sep-

tembre 2014, à 9.00 heures, au siège social, en

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

tenue extraordinairement, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Lecture des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice
clos le 31 décembre 2013, approbation desdits comptes, décharge aux administrateurs et au Commissaire aux
Comptes.

Affectation du résultat.

Questions diverses.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014126099/17.

Flaugust S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 7A, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 132.854.

Messieurs, Mesdames, les actionnaires, nous avons l'honneur de vous informer que vous êtes convoqués, le <i>26 sep-

<i>tembre 2014 , à 10.00 heures, au siège social, en

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE TENUE EXTRAORDINAIREMENT

à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Lecture des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice
clos le 31 décembre 2013, approbation desdits comptes, décharge aux administrateurs et au Commissaire aux
Comptes,

Affectation du résultat,

Questions diverses.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014126100/17.

Comfintex S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 21.707.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mercredi <i> 1 

<i>er

<i> octobre 2014  à 11.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et des rapports du Commissaire aux Comptes,

Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2010, 31 décembre 2011, 31 décembre 2012 et 31 décembre
2013 et affectation des résultats,

Décision à prendre quant à la poursuite de l'activité de la société,

Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,

Nominations statutaires,

Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l'assemblée au siège social.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014141230/755/20.

116450

L

U X E M B O U R G

Auber S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 7A, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 121.682.

Messieurs, Mesdames, les actionnaires, nous avons l'honneur de vous informer que vous êtes convoqués, <i>le 26 sep-

<i>tembre 2014 , à 11.00 heures, au siège social, en

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE TENUE EXTRAORDINAIREMENT

à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Lecture des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice
clos le 31 décembre 2013, approbation desdits comptes, décharge aux administrateurs et au Commissaire aux
Comptes,

Affectation du résultat,

Questions diverses.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014126101/17.

Montinvest International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 7A, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 79.761.

Messieurs, Mesdames, les actionnaires, nous avons l'honneur de vous informer que vous êtes convoqués, <i>le 26 sep-

<i>tembre 2014 , à 14.00 heures, au siège social, en

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE TENUE EXTRAORDINAIREMENT

à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Lecture des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice
clos le 31 décembre 2013, approbation desdits comptes, décharge aux administrateurs et au Commissaire aux
Comptes,

Affectation du résultat,

Questions diverses.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014126102/17.

Caelus Energy International Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 1.400.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 174.400.

EXTRAIT

En date du 3 juillet 2014, Caelus Energy Partners L.P. a cédé toutes les 140.000.000 de parts sociales de 10 différentes

classes (soit 14.000.000 parts sociales par classe A à J) qu'elle détenait dans la Société à Samudra Energy East Kalimantan
Limited, une société existant en vertu des lois des îles Vierges britanniques, immatriculée auprès de Financial Services
Commission sous le numéro 1739257 et ayant son siège social au P.O. Box 3444-, Road Town, Tortola, îles Vierges
britanniques.

Suite à ce transfert, Caelus Energy Partners L.P. ne détient plus de parts sociales dans la Société de sorte que toutes

les parts sociales de la Société sont détenues par Samudra Energy East Kalimantan Limited.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 juillet 2014.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2014101792/20.
(140121881) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2014.

116451

L

U X E M B O U R G

Russian Mortgage Backed Securities 2006-1 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 112.785.

La décision suivante a été prise par l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société qui s'est tenue en date

du 19 juin 2014:

- de renouveler le mandat d'Ernst and Young en tant que réviseur d'entreprise agréé de la Société avec effet immédiat

et pour une période arrivant à échéance lors de l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires à tenir en 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 juillet 2014.

<i>Pour la Société
Shehzaad Atchia
<i>Administrateur

Référence de publication: 2014099389/16.
(140118007) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2014.

Castle Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 7A, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 72.963.

Messieurs, Mesdames, les actionnaires, nous avons l'honneur de vous informer que vous êtes convoqués, <i>le 26 sep-

<i>tembre 2014 , à 17.00 heures, au siège social, en

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE TENUE EXTRAORDINAIREMENT

à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Lecture des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice
clos le 31 décembre 2013, approbation desdits comptes, décharge aux administrateurs et au Commissaire aux
Comptes,

Affectation du résultat,

Questions diverses.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014126104/17.

China Designer Outlet Mall S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 168.248.

The shareholders of the Company are hereby convened to the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on <i>September 30, 2014 at 10.00 a.m. at the registered office of the Company with the following

agenda:

<i>Agenda:

1. Perusal of the report of the supervisory auditor.
2. Approval of the annual accounts as of December 31, 2013.
3. Appropriation of results as of December 31, 2013.
4. Discharge to the Directors and to the supervisory auditor for the performance of their mandates during the related

fiscal year.

5. Decision on the Company's dissolution according to article 100 of the amended Companies' law of August 10,

1915.

6. Statutory appointments/reappointments.
7. Miscellaneous.

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2014141229/729/21.

116452

L

U X E M B O U R G

UniInstitutional European Corporate Bonds +, Fonds Commun de Placement.

Das koordinierte Verwaltungsreglement, welches am 10. Juni 2014 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesell-

schaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 12. Juni 2014.

Union Investment Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2014082697/10.
(140097663) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2014.

UniInstitutional European Corporate Bonds +, Fonds Commun de Placement.

Das koordinierte Sonderreglement, welches am 10. Juni 2014 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschafts-

register von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 12. Juni 2014.

Union Investment Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2014082698/10.
(140097664) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2014.

UniKonzept: Portfolio, Fonds Commun de Placement.

Das koordinierte Verwaltungsreglement, welches am 10. Juni 2014 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesell-

schaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 12. Juni 2014.

Union Investment Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2014082695/10.
(140097661) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2014.

UniKonzept: Portfolio, Fonds Commun de Placement.

Das koordinierte Sonderreglement, welches am 10. Juni 2014 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschafts-

register von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 12. Juni 2014.

Union Investment Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2014082696/10.
(140097662) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2014.

Next Real Estate Polish Retail Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 155.265.

En date du 1 

er

 février 2014, Piotr Ziarkowski, avec adresse au 53, Emilii Plater, 00113 Warszawa, Pologne, a démis-

sionné de son mandat de gérant de la société Next Real Estate Polish Retail Holdco S.à r.l., avec siège social au 7A, rue
Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 155265

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juin 2014.

Alter Domus Luxembourg S.à r.l.
<i>Mandaté par le démissionnaire

Référence de publication: 2014099318/14.
(140118245) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2014.

116453

L

U X E M B O U R G

EuroSwitch Balanced Portfolio OP, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement - Besonderer Teil - des jeweiligen Fonds wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister

von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Oppenheim Asset Management Services S.à r.l.
Unterschriften

Référence de publication: 2014133286/10.
(140150944) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2014.

EuroSwitch Defensive Concepts OP, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement - Besonderer Teil - des jeweiligen Fonds wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister

von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Oppenheim Asset Management Services S.à r.l.
Unterschriften

Référence de publication: 2014133288/10.
(140150952) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2014.

GLL Real Estate Selection Fund, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion au 20 août 2014 du fonds commun de placement GLL Real Estate Selection Fund a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

GLL Management Company S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2014137203/10.
(140155970) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2014.

GPIM Themis, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion modifié au 22 juillet 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 juillet 2014.

IPConcept (Luxemburg) S.A.

Référence de publication: 2014108581/10.
(140129120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2014.

LF Real Estate S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 37C, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 163.908.

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Luxembourg,

en date du 11 octobre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association n° 2877 du 24 novembre 2011.

Les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LF Real Estate S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2014098398/14.
(140117923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2014.

116454

L

U X E M B O U R G

Ginkgo No. 1, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion modifié au 22 juillet 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 juillet 2014.

IPConcept (Luxemburg) S.A.

Référence de publication: 2014109542/10.
(140130841) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2014.

Olivetree Absolute Return, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion modifié au 22 juillet 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 juillet 2014.

IPConcept (Luxemburg) S.A.

Référence de publication: 2014108579/10.
(140129118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2014.

Adel-Fis, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Le règlement de gestion modifié au 22 juillet 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 juillet 2014.

IPConcept (Luxemburg) S.A.

Référence de publication: 2014107645/10.
(140129048) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2014.

Bond Relative Return, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Le règlement de gestion modifié au 22 juillet 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 juillet 2014.

IPConcept (Luxemburg) S.A.

Référence de publication: 2014108580/10.
(140129119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2014.

Goldorak Investments, Société Anonyme.

Siège social: L-1260 Luxembourg, 5, rue de Bonnevoie.

R.C.S. Luxembourg B 184.043.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 juillet 2014.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Maître Carlo WERSANDT
<i>Notaire

Référence de publication: 2014098240/14.
(140117566) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2014.

116455

L

U X E M B O U R G

GERES Investment S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 118.472.

EXTRAIT

Au 28 mai 2014 Mr Finbarr Browne a été nominé «Geschäfstfüihrer» de la société
en remplacement de Mr Gary Janaway.
L'adresse de Mr Finbarr Browne est la suivante:
5, rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg
G.D. Luxembourg

Luxembourg, le 10 juin 2014.

Robbert Van Zinnicq Bergmann / Paul Farmer
<i>Authorised Signatory / Authorised Signatory

Référence de publication: 2014099992/17.
(140119606) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2014.

Generation S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, Avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 157.518.

EXTRAIT

Il résulte de l’assemblée générale des actionnaires de la Société tenue en date du 4 septembre 2014, que:
- Le siège social de la Société a été transféré au 35, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg;
- Il a été mis fin, avec effet immédiat, aux mandats d’administrateurs de la Société de MM. Martin Gruschka et Roderick

Egli;

- M. Denis Van Den Bulke, né le 10 juillet 1959 à Liège, Belgique, avec adresse professionnelle au 35, avenue Monterey,

L-2163 Luxembourg et Mme Laurence Jacques, née le 11 avril 1977 à Verviers, Belgique, avec adresse professionnelle au
35, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg ont été nommés, jusqu'à l’assemblée générale annuelle des actionnaires devant
se tenir en 2017, avec effet au 4 septembre 2014, en tant qu'administrateurs de la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Generation S.A.

Référence de publication: 2014139590/18.
(140158047) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2014.

Tamata S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 14.000,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, Avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 132.921.

EXTRAIT

Il résulte de l’assemblée générale des associés de la Société tenue en date du 4 septembre 2014, que:
- Le siège social de la Société a été transféré au 35, avenue Monterey L-2163 Luxembourg;
- Il a été mis fin, avec effet immédiat, aux mandats de gérants de classe A de la Société de MM. Martin Gruschka et

Roderick Egli;

- M. Denis Van Den Bulke, né le 10 juillet 1959 à Liège, Belgique, avec adresse professionnelle au 35, avenue Monterey,

L-2163 Luxembourg et Mme Laurence Jacques, née le 11 avril 1977 à Verviers, Belgique, avec adresse professionnelle au
35, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg ont été nommés, pour une durée indéterminée, avec effet au 4 septembre
2014, en tant que gérants de classe A de la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Tamata S.à r.l.

Référence de publication: 2014139952/19.
(140158175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2014.

116456

L

U X E M B O U R G

Cordial Arrow Fund, Fonds Commun de Placement.

CORDIAL ARROW FUND (the “Fund”) has been put into liquidation with effect from 13 

th

 March 2014.

The liquidation proceeds were paid to the remaining unitholders on 19 

th

 March 2014.

No amount has been deposited to the Caisse de Consignation in Luxembourg.
The accounts and the records of the Fund will be kept for a period of five years at the offices of SMBC Nikko Bank

(Luxembourg) S.A., 9A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg.

Référence de publication: 2014140028/9.

Andante, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Die Verwaltungsgesellschaft des Luxemburger Sondervermögens „Andante“ (ISIN: LU032143022; WKN: A0M1NH)

hat am 14. August 2014 beschlossen, den Fonds aufzulösen und zum 26. August 2014 zu liquidieren.

Luxemburg, im September 2014.

Oppenheim Asset Management Services S.à r.l.
4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg

Référence de publication: 2014141231/1999/9.

Altaira Funds, Fonds Commun de Placement.

Gemäß dem Beschluss des Verwaltungsrates der Verwaltungsgesellschaft wird der Teilfonds ALTAIRA Funds - Global

Tactical Solution zum 10. September 2014 aus wirtschaftlichen Gründen aufgelöst und von der offiziellen Liste für Or-
ganismen für gemeinsame Anlagen gestrichen.

Hinweis zur Bekanntmachung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Association.

Luxemburg, im September 2014.

VPB-FINANCE S.A.

Référence de publication: 2014141232/9.

PBN Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 153.563.

DISSOLUTION

In the year two thousand fourteen, on the twentieth day of August.
Before the undersigned Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

S1 Projekt APM Sp. z o.o. S.K.A., a company existing under the Polish Laws, registered in the Regional Court of Warsaw,

XIII Commercial Department of the National Court Register under KRS number 0000488762, with its registered office
at ul. Hozjusza 5A lok. 3, 01-565 Warsaw, Poland,

here represented by Mr Raphaël BENAYOUN, companies director, residing professionally at 23, rue Aldringen L-1118

Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on July 30, 2014.

The said proxy, after having been signed “ne varietur” by the proxyholder of the appearing party and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated above, has requested the undersigned notary to state:
- that it is the sole actual shareholder of the company “PBN INVESTMENT S.A.”, having its registered office at L-1118

Luxembourg, 23, rue Aldringen, registered with RCS Luxembourg under number B 153.563 (The “Company”), incorpo-
rated pursuant to a notarial deed on May 31 

st

 , 2010, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations,

number 1479 of July 20 

th

 , 2010. The Articles have not been amended since then;

- that the capital of the Company is fixed at thirty-one thousand euros (EUR 31.000,-) represented by one thousand

(1,000) shares with a par value of thirty-one euros (EUR 31.-) each, fully paid up;

- that the appearing party, prenamed, has become owner of all the shares and declares that it has full knowledge of

the articles of incorporation and the financial standing of the Company;

- that the appearing party, represented as stated above, in its capacity as sole shareholder of the Company, has resolved

to proceed to the anticipatory and immediate dissolution of the Company and to put it into liquidation;

116457

L

U X E M B O U R G

- that the sole shareholder, represented as stated above, in its capacity as liquidator of the Company, and according

to the balance sheet of the Company as at August 14, 2014, declares that all the liabilities of the Company, including the
liabilities arising from the liquidation, are settled or retained.

The appearing party furthermore declares that:
- the Company’s activities have ceased;
- the sole shareholder is thus vested with all the assets of the Company and undertakes to settle all and any liabilities

of the terminated Company, the balance sheet of the Company as at August 14, 2014 being only one information for all
purposes;

- following to the above resolutions, the Company’s liquidation is to be considered as accomplished and closed;
- the Company’s directors and statutory auditor are hereby granted full discharge with respect to their duties;
- there shall be proceeded to the cancellation of all issued shares and/or the shareholders register;
- the books and documents of the Company shall be lodged during a period of five years at L-1118 Luxembourg, 23,

rue Aldringen.

No confusion of patrimony can be made, neither with the assets of the dissolved company nor the reimbursement to

the sole shareholder can be done, before a period of thirty days (article 69 (2) of the law on commercial companies) to
be counted from the day of publication of the present deed, and only if no creditor of the Company currently dissolved
and liquidated has demanded the creation of security.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded

in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.

<i>Costs

The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it

by reason of the present deed are estimated approximately at one thousand euros (1,000.- EUR).

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, who is known to the notary by his surname,

first name, civil status and residence, the said person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le vingt août.
Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

S1 Projekt APM Sp. z o.o. S.K.A., une société existant sous le droit polonais, enregistré au tribunal régional de Varsovie,

Direction Commerciale XIII du registre national sous le numéro KRS 0000488762, avec son siège social à ul. Hozjusza
5A lok. 3, 01-565, Varsovie, Pologne,

ici représentée par Monsieur Raphaël BENAYOUN, administrateur de sociétés, résidant professionnellement au 23,

rue Aldringen, L-1118 Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privée du 30 juillet 2014.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de la comparante et le notaire

instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d'acter:
- qu’elle est la seule et l'unique actionnaire de la société PBN INVESTMENT S.A., ayant son siège social à L-1118

Luxembourg, 23, rue Aldringen, immatriculée au RCS Luxembourg sous le numéro B 153.563 (la «Société»), constituée
suivant un acte notarié en date du 31 mai 2010, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1479
du 20 juillet 2010; Les statuts n’ont pas été modifiés depuis;

- que le capital social de la Société s'élève à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions

d'une valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR) chacune, entièrement libérées;

- que la partie comparante, précitée, est devenue seule propriétaire de toutes les actions et qu’elle déclare avoir parfaite

connaissance des statuts et de la situation financière de la Société;

- que la partie comparante, représentée comme mentionné ci-avant, en sa qualité d’actionnaire unique de la Société,

a décidé de procéder à la dissolution anticipée et immédiate de la Société et de la mettre en liquidation;

- que l'actionnaire unique, en sa qualité de liquidateur de la Société et au vu du bilan de la Société au 14 août 2014,

déclare que tout le passif de la Société, y compris le passif lié à la liquidation de la Société, est réglé ou dûment provisionné.

La partie comparante déclare encore que:
- l'activité de la Société a cessé;

116458

L

U X E M B O U R G

- l'actionnaire unique est investi de l'entièreté de l'actif de la Société et déclare prendre à sa charge l'entièreté du passif

de la Société qu’il soit connu et impayé, ou inconnu et non encore payé, le bilan au 14 août 2014 étant seulement un des
éléments d’information à cette fin;

- suite aux résolutions ci-avant, la liquidation de la Société est à considérer comme accomplie et clôturée;
- décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société;
- il y a lieu de procéder à l'annulation de toutes les actions et/ou du registre des actionnaires;
- les livres et documents de la Société devront être conservés pendant la durée légale de cinq ans à L-1118 Luxembourg,

23, rue Aldringen.

Toutefois, aucune confusion de patrimoine entre la société dissoute et l'avoir social de, ou remboursement à, l'ac-

tionnaire unique ne pourra se faire avant le délai de trente jours (article 69 (2) de la loi sur les sociétés commerciales) à
compter de la publication du présent acte et sous réserve qu’aucun créancier de la Société présentement dissoute et
liquidée n’aura exigé la constitution de sûretés.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la partie comparante l'a

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison de présentes, sont évalués approximativement à mille euros (1.000,- EUR).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: R. BENAYOUN, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg, Actes Civils, le 21 août 2014. Relation: LAC/2014/39299. Reçu soixante-quinze euros (EUR

75,-).

<i>Le Receveur

 (signé): I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg, le 4 septembre 2014.

Référence de publication: 2014139165/110.
(140157667) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2014.

Georgia-Pacific Andes S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 146.968.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014095894/9.
(140114839) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2014.

The Archstone German Residential Fund II, Fonds Commun de Placement.

EXTRAIT POUR PUBLICATION

Archstone Management Germany II S.à r.l. a décidé de résilier le règlement de gestion du fonds The Archstone German

Residential Fund II avec effet au 1 

er

 juillet 2014 et de dissoudre le fonds. Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

a confirmé la résiliation de contrats relatifs au fonds.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juillet 2014.

<i>Pour la société
Archstone Management Germany II S.à r.l.

Référence de publication: 2014141228/267/12.

116459

L

U X E M B O U R G

33 Grosvenor Place Limited, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 22, Grand-Rue.

R.C.S. Luxembourg B 189.660.

In the year two thousand and fourteen, on the fourteenth day of August.
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Iron Grafton S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under

the laws  of Grand  Duchy  of Luxembourg,  registered  with Luxembourg Trade  and Companies Register  (Registre  de
Commerce et des Sociétés) under number B 187.830, having a share capital of eleven thousand nine hundred twenty-five
British Pounds (GBP 11,925) and having its registered office at 22, Grand-Rue, 3 

rd

 Floor, L-1660 Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg,

here represented by Regis Galiotto, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private

seal.

The said proxy, initialed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed

to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated above, declare having waived any notice requirement, the general meeting

of shareholders is regularly constituted and may validly deliberate. The appearing party has requested the undersigned
notary to state that:

A. The appearing party is the sole shareholder of the 33 Grosvenor Place Limited, a company limited by shares,

incorporated and existing under the laws of Jersey, registered with the Jersey Financial Services Commission under the
registration number 95361, having a share capital of twenty-three million two hundred forty-eight thousand three hundred
eighty-four British Pounds and forty-six pence (GBP 23,248,384.46) and registered office at 1 Waverley Place, Union
Street, St Helier, Jersey JE1 1 SG and complies with the requirements of the Luxembourg law in respect of a private
limited liability company (société à responsabilité limitée) (the “Company”), representing the entire share capital of the
Company, (the “Sole Shareholder”);

B. The agenda is worded as follows:

<i>Agenda:

1. Amendment of the articles of association of the Company (the “Articles”) to insert the new article 14 that shall be

read as follows:

“ 14. Share Security.
14.1 Despite anything to the contrary contained in these Articles:
(i) the Managers shall promptly register (and may not decline to register) the transfer of any shares (the “Secured

Shares”) over which a security interest (the “security interest”) has been granted pursuant to a security agreement (the
“Security Agreement”) on receiving a signed and completed instrument of transfer (in a form required or permitted by
these Articles) in respect of any of the Secured Shares if the transferee is a person:

(1) entitled to the benefit of the security interest pursuant to the Security Agreement or any person acting as agent,

trustee or nominee for that person (the “Secured Party”); or

(2) to whom any of the Secured Shares are to be transferred by:
(A) the grantor of the security interest or any person acting as agent, trustee or nominee for the grantor; or
(B) the Secured Party,
as a result of the creation or perfection of the security interest, the enforcement of the security interest or the exercise

by the Secured Party of any of its rights under the Security Agreement;

(ii) no fee shall be payable in respect of the registration of any transfer of any of the Secured Shares pursuant to, or

in connection with, the Security Agreement;

(iii) the Managers may not suspend the registration of transfers of shares upon receiving an instrument of transfer in

respect of any of the Secured Shares and any suspension in effect prior to the receipt of any such instrument of transfer
shall not apply to the Secured Shares; and

(iv) the Secured Shares shall be exempt from any present or future lien in favour of the Company that might otherwise

have arisen under these Articles and the Company shall not assert any lien against any of the Secured Shares while they
remain subject to the security interest.

14.2 A certificate from an authorised signatory of the Secured Party that:
(i) a transfer of any Secured Shares relates to the creation or perfection of the security interest, the enforcement of

the security interest or the exercise by the Secured Party of any of its rights under the Security Agreement; or

(ii) any of the Secured Shares remains subject to the security interest,

116460

L

U X E M B O U R G

shall (in the absence of fraud) be conclusive evidence of that fact.
14.3 To the extent that this article is inconsistent with any other provision of these Articles, this article shall prevail.”
2. Renumbering of the former articles 14 to 40 as articles 15 to 41.
3. Miscellaneous.

Having duly considered each item on the agenda, the appearing party unanimously takes, and requires the undersigned

notary to enact, the following resolutions:

<i>First Resolution

The Sole Shareholder resolves to approve the amendment of the Articles to insert the new article 14 that shall be

read as follows:

“ 14. Share Security.
14.1 Despite anything to the contrary contained in these Articles:
(i) the Managers shall promptly register (and may not decline to register) the transfer of any shares (the “Secured

Shares”) over which a security interest (the “security interest”) has been granted pursuant to a security agreement (the
“Security Agreement”) on receiving a signed and completed instrument of transfer (in a form required or permitted by
these Articles) in respect of any of the Secured Shares if the transferee is a person:

(1) entitled to the benefit of the security interest pursuant to the Security Agreement or any person acting as agent,

trustee or nominee for that person (the Secured Party); or

(2) to whom any of the Secured Shares are to be transferred by:
(A) the grantor of the security interest or any person acting as agent, trustee or nominee for the grantor; or
(B) the Secured Party,
as a result of the creation or perfection of the security interest, the enforcement of the security interest or the exercise

by the Secured Party of any of its rights under the Security Agreement;

(ii) no fee shall be payable in respect of the registration of any transfer of any of the Secured Shares pursuant to, or

in connection with, the Security Agreement;

(iii) the Managers may not suspend the registration of transfers of shares upon receiving an instrument of transfer in

respect of any of the Secured Shares and any suspension in effect prior to the receipt of any such instrument of transfer
shall not apply to the Secured Shares; and

(iv) the Secured Shares shall be exempt from any present or future lien in favour of the Company that might otherwise

have arisen under these Articles and the Company shall not assert any lien against any of the Secured Shares while they
remain subject to the security interest.

14.2 A certificate from an authorised signatory of the Secured Party that:
(i) a transfer of any Secured Shares relates to the creation or perfection of the security interest, the enforcement of

the security interest or the exercise by the Secured Party of any of its rights under the Security Agreement; or

(ii) any of the Secured Shares remains subject to the security interest, shall (in the absence of fraud) be conclusive

evidence of that fact.

14.3 To the extent that this Article is inconsistent with any other provision of these articles, this article shall prevail.”

<i>Second Resolution

The Sole Shareholder resolves to renumber the former articles 14 to 40 as articles 15 to 41.

<i>Costs and Expenses

The costs, expenses, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of this deed are

estimated at one thousand five hundred Euros (EUR 1,500.-).

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,

this deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing party and in case
of discrepancy between the English and the French text, the English version shall prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name

and residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le quatorzième jour du mois d'août.
Par-devant nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

116461

L

U X E M B O U R G

Iron Grafton S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existante sous les lois du Grand-Duché de

Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 187.830, ayant un
capital social de onze mille neuf cent vingt-cinq livres sterling (GBP 11,925) et ayant son siège social au 22, Grand-Rue, 3

ème

 étage, L-1660 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

ici représenté par Regis Galiotto, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée

sous seing privé.

Ladite procuration, paraphée ne varietur par le mandataire du comparant et par le notaire, restera annexée au présent

acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

Le comparant représentant l'intégralité du capital social déclare avoir renoncé à toute formalité de convocation, l'as-

semblée générale de l'associé unique est ainsi régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points
figurant à l'ordre du jour suivant:

A. Le comparant est l'associé unique de 33 Grosvenor Place Limited, une société en commandite par actions, constituée

et existante sous les lois de Jersey, inscrite au Jersey Financial Services Commission sous le numéro 95361, ayant un
capital social de vingt-trois millions deux-cent quarante-huit mille trois-cent quatre-vingt-quatre livres sterling et quarante-
six cents (23.248.384,46 GBP) et ayant son siège social au 1 Waverley Place, Union Street, St. Helier, Jersey, JE1 SG et
se conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise relative à la société à responsabilité limitée (la «Société»), repré-
sentant l'entièreté du capital social de la Société (l'«Associé Unique»).

B. L'ordre du jour est rédigé comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Modification des statuts de la Société (les «Statuts») en insérant un nouvel article 14 qui se lit comme suit:
« 14. Sûretés des Parts Sociales.
14.1 Malgré toute disposition contraire dans les Présents Statuts:
(i) les Gérants doivent sans délai inscrire (et ne peuvent pas refuser d'inscrire) le transfert de toutes Parts Sociales

(les «Parts Sociales Gagées») sur lesquelles une sûreté réelle (la «sûreté») a été accordée en vertu d'un contrat de sûreté
(le «Contrat de Sûreté») à la réception d'un document de transfert signé et complet (en une forme requise ou permise
par les Présents Statuts) concernant toutes Parts Sociales avec Sûreté, si le cessionnaire est une personne:

(1) ayant droit au bénéfice de la sûreté en vertu du Contrat de Sûreté ou toute personne agissant comme agent,

fiduciaire or personne nommée pour cette personne (la «Partie Bénéficiaire»); ou

(2) à laquelle toute Part Sociale Gagée doit être transférée par:
(A) le constituant de la sûreté ou toute personne agissant comme agent, fiduciaire ou personne nommée pour le

constituant; ou

(B) la Partie Bénéficiaire,
du fait de la constitution ou l'opposabilité de la sûreté, l'exécution de la sûreté ou l'exercice par la Partie Bénéficiaire

de l'un de ses droits sous le Contrat de Sûreté;

(ii) aucun frais n'est dû en ce qui concerne l'inscription de tout transfert de toutes Parts Sociales Gagées en vertu de,

ou en lien avec, le Contrat de Sûreté;

(iii) les Gérants ne peuvent pas suspendre l'inscription de transfert de parts sociales à la réception d'un document de

transfert concernant toute Parts Sociale Gagée et toute suspension en force avant la réception d'un tel document de
transfert ne s'applique pas aux Parts Sociales Gagées; et

(iv) les Parts Sociales Gagées sont exemptées de tout privilège présent ou futur en faveur de la Société qui autrement

auraient pu survenir sous les Présents Statuts et la Société ne revendiquera aucun privilège contre toutes Parts Sociales
Gagées tant qu'elles sont soumises à la sûreté.

14.2 Un certificat d'un signataire autorisé de la Partie Bénéficiaire certifiant que:
(i) un transfert de toute Part Sociale Gagée se rapporte à la constitution ou l'opposabilité de la sûreté, l'exécution de

la sûreté ou l'exercice par la Partie Bénéficiaire de l'un de ses droits sous le Contrat de Sûreté; ou

(ii) toutes Part Sociales Gagées restent soumises à la sûreté, seront (en l'absence de fraude) la preuve concluante de

ce fait.

14.3 Dans la mesure où cet article serait incompatible avec toute autre disposition des présents Statuts, cet article

doit prévaloir.»

2. La renumérotation des anciens articles 14 à 40 en 15 à 41.
3. Divers.

Ayant dûment considéré chaque élément de l'ordre du jour, la partie comparante prend à l'unanimité, et requièrent

du notaire soussigné d'acter, les résolutions suivantes:

<i>Première Résolution

L'Associé Unique décide d'approuver la modification des Statuts en insérant un nouvel article 14 qui se lit comme suit:

116462

L

U X E M B O U R G

« 14. Sûretés des Parts Sociales.

14.1 Malgré toute disposition contraire dans les Présents Statuts:

(i) les Gérants doivent sans délai inscrire (et ne peuvent pas refuser d'inscrire) le transfert de toutes Parts Sociales

(les «Parts Sociales Gagées») sur lesquelles une sûreté réelle (la «sûreté») a été accordée en vertu d'un contrat de sûreté
(le «Contrat de Sûreté») à la réception d'un document de transfert signé et complet (en une forme requise ou permise
par les Présents Statuts) concernant toutes Parts Sociales avec Sûreté, si le cessionnaire est une personne:

(3) ayant droit au bénéfice de la sûreté en vertu du Contrat de Sûreté ou toute personne agissant comme agent,

fiduciaire or personne nommée pour cette personne (la «Partie Bénéficiaire»); ou

(4) à laquelle toute Part Sociale Gagée doit être transférée par:

(A) le constituant de la sûreté ou toute personne agissant comme agent, fiduciaire ou personne nommée pour le

constituant; ou

(B) la Partie Bénéficiaire,

du fait de la constitution ou l'opposabilité de la sûreté, l'exécution de la sûreté ou l'exercice par la Partie Bénéficiaire

de l'un de ses droits sous le Contrat de Sûreté;

(ii) aucun frais n'est dû en ce qui concerne l'inscription de tout transfert de toutes Parts Sociales Gagées en vertu de,

ou en lien avec, le Contrat de Sûreté;

(iii) les Gérants ne peuvent pas suspendre l'inscription de transfert de parts sociales à la réception d'un document de

transfert concernant toute Parts Sociale Gagée et toute suspension en force avant la réception d'un tel document de
transfert ne s'applique pas aux Parts Sociales Gagées; et

(iv) les Parts Sociales Gagées sont exemptées de tout privilège présent ou futur en faveur de la Société qui autrement

auraient pu survenir sous les Présents Statuts et la Société ne revendiquera aucun privilège contre toutes Parts Sociales
Gagées tant qu'elles sont soumises à la sûreté.

14.2 Un certificat d'un signataire autorisé de la Partie Bénéficiaire certifiant que:

(i) un transfert de toute Part Sociale Gagée se rapporte à la constitution ou l'opposabilité de la sûreté, l'exécution de

la sûreté ou l'exercice par la Partie Bénéficiaire de l'un de ses droits sous le Contrat de Sûreté; ou

(ii) toutes Part Sociales Gagées restent soumises à la sûreté, seront (en l'absence de fraude) la preuve concluante de

ce fait.

14.3 Dans la mesure où cet article serait incompatible avec toute autre disposition des présents Statuts, cet article

doit prévaloir.»

<i>Deuxième Résolution

L'Associé Unique décide de renuméroter les anciens articles 14 à 40 en 15 à 41.

<i>Frais et Dépenses

Le montant des frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature qui incombe à la Société en raison de cet acte

est évalué à environ mille cinq cents Euros (EUR 1.500,-).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande du comparant, le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d'une traduction en français; et qu'à la demande du même comparant et en cas de divergence
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

L'acte ayant été lu au mandataire du comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom, et résidence,

ledit mandataire des comparantes a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 21 août 2014. Relation: LAC/2014/39268. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 4 septembre 2014.

Référence de publication: 2014139324/210.

(140157596) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2014.

116463

L

U X E M B O U R G

Styrolution Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.700,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 189.956.

ENTWURF DES GEMEINSAMEN VERSCHMELZUNGSPLANS

COMMON DRAFT TERMS OF CROSS BORDER MERGER

Styrolution Luxembourg S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Statutory Seat:
Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg
Trade and Companies Register of Luxembourg (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg), Luxembourg,
Under process of registration with the Trade and Companies Register of Luxembourg.

Styrolution Group GmbH
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Statutory Seat:
Frankfurt am Main,
Germany
Commercial register of the local court Frankfurt am Main, Germany, Commercial Register number, HRB 91762

<i>Common Draft Terms of Cross-Border Merger

The management of Styrolution Group GmbH, Frankfurt am Main, Germany, and the management of Styrolution

Luxembourg S.à r.l., Luxembourg, Luxembourg, hereby in accordance with Sec. 122 subs. 1 and 2 UmwG as well as Section
XIV of the Law dated August 10, 1915 related to the commercial companies as modified (the Law dated August 10, 1915)
agree on the following Common Draft Terms of Cross-Border Merger (the Common Draft Terms of Cross-Border
Merger) for the merger of Styrolution Luxembourg S.à r.l. into Styrolution Group GmbH (the Merger).

The Merger shall be a cross-border merger effected in accordance with the provisions introduced in Luxembourg and

in the Federal Republic of Germany to implement Directive 2005/56/EC of the European Parliament and of the Council
of 26 October 2005 (the Directive 2005/56/EC) on cross-border mergers of limited liability companies based in different
member states. In Luxembourg, the Merger will be effected in accordance with Articles of Section XIV of the Law dated
August 10, 1915; in the Federal Republic of Germany, the Merger will be effected in accordance with the provisions of
the Tenth Section of the Second Part of the Second Book of the German Transformation Act (Umwandlungsgesetz;
UmwG).

MERGER PLAN

1. Merging Companies (Sec. 122c subs. 2 no. 1 UmwG as well as Articles 261 (2) a) of the Law dated August 10, 1915);

special rights (Sec. 23 UmwG as well as Artikel 261 (2) f) of the Law dated August 10, 1915).

1.1 The acquiring company in the Merger is Styrolution Group GmbH, a private company with limited liability under

German law having its statutory seat in Frankfurt am Main, Germany, and its business address in Erlenstraße 2, 60325
Frankfurt am Main, which is registered in the commercial register of the Local Court of Frankfurt am Main under HRB
91762.

The share capital of Styrolution Group GmbH is EUR 10,000,000 (in words: Euros Ten Million). It consists of 10,000,000

shares in the nominal value of each EUR 1 (in words: one Euro) of which all capital contributions have been fully paid. In
addition there exist no special rights within the meaning of Section 23 UmwG, Article 261 (2) f) of the Law dated August
10, 1915, respectively.

The sole shareholder of Styrolution Group GmbH is Styrolution Beteiligungs GmbH with its statutory seat in Frankfurt

am Main, Germany, registered with the commercial register of the Local Court of Frankfurt am Main under HRB 91761.

1.2 The transferring company in the Merger is Styrolution Luxembourg S.à r.l., a private limited liability company

(Société à responsabilité limitée), incorporated and existing under the law of the Grand Duchy of Luxembourg, having
its registered office in L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert, under process of registration with the Trade and
Companies Register of Luxembourg (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg).

The share capital of Styrolution Luxembourg S.à r.l. amounts to EUR 12,700 (in words: Euros twelve thousand seven

hundred). It is divided into 12,700 shares having a nominal value of each EUR 1 (in words: one Euro) of which all capital
contributions have been fully paid. Styrolution Luxembourg S.à r.l. has no special rights within the meaning of Section 23
UmwG, Article 261 (2) f) of the Law dated August 10, 1915, respectively.

116464

L

U X E M B O U R G

The sole shareholder of Styrolution Luxembourg S.à r.l. is Styrolution Group GmbH.

2. Transfer of Assets and Liabilities, Effect of the Merger. Styrolution Luxembourg S.à r.l. transfers to Styrolution Group

GmbH all of its assets and liabilities together with all rights and obligations under dissolution without liquidation (Auflösung
ohne Abwicklung) by way of a cross-border merger by absorption (Verschmelzung durch Aufnahme) pursuant to Sections
2 no. 1, 46 et seq., 122 a et seq. UmwG and Sub-Section III of the Section XIV related to the mergers of the Law dated
August 10, 1915. The Merger is a so-called “upstream merger of a wholly-owned subsidiary by absorption” whereby the
subsidiary company is merged into its parent company.

The Merger is performed according to Section 122c subs. 3 as well as Section 122a subs. 2 in connection with Section

5 subs. 2 UmwG and Article 278 of the Law dated August 10, 1915 without consideration for the transfer of the assets,
as the acquiring company holds all shares in the transferring company.

According to Sec. 20 subs. 1 no. 2 UmwG and Article 274 of the Law dated August 10, 1915, respectively, the Merger

results in the automatic transfer of all assets and liabilities of Styrolution Luxembourg S.à r.l. to Styrolution Group GmbH.

Styrolution Luxembourg S.à r.l. shall ipso jure cease to exist as at the legal effective date of the Merger (registration

of the Merger in the commercial register of the Local Court of Frankfurt am Main, Germany).

3. Exchange Ratios; Entitlement to Dividends; Cash Compensation (Sec. 122c subs. 2 no. 2, no. 3 and no. 5 UmwG as

well as Article 261 (2) b), c) and d) of the Law dated August 10, 1915). Styrolution Group GmbH holds all shares in
Styrolution Luxembourg S.à r.l. Therefore, a capital increase is not permitted according to Sec. 54 subs. 1 sentence 1
number 1 UmwG. Thus, according to Sec. 122c subs. 3 UmwG and Article 278 of the Law dated August 10, 1915 it is
not required to provide any information in relation to the exchange of shares according to Sec. 122c subs. 2 no. 2, no. 3
and no. 5 UmwG and Article 278 of the Law dated August 10, 1915 respectively.

4. Balance Sheet; Merger Closing Date; Valuation according to Sec. 122 c subs. 2 no. 6, no. 11 and no. 12 UmwG as

well as Article 261 (4) d) and e) of the Law dated August 10, 1915.

4.1 The Merger is based on the balance sheets of Styrolution Luxembourg S.à r.l. as of 5 September 2014 and of

Styrolution Group GmbH as of 31 December 2013.

4.2 The balance sheets mentioned in no. 4.1 provide also the basis for the determination of the terms of the Merger

according to Sec. 122c subs. 2 no. 12 UmwG as well as Article 261 (4) e) of the Law dated August 10, 1915.

The acquisition of the assets and liabilities of Styrolution Luxembourg S.à r.l. and Styrolution Group GmbH shall be

performed for economic and accounting purposes as of the beginning of 6 September 2014, 0:00 o'clock. As of that date
all actions and transactions of Styrolution Luxembourg S.à r.l. shall be deemed as carried out for the account of Styrolution
Group GmbH (Merger Closing Date according to Section 122c subs. 2 no. 6 UmwG - Verschmelzungsstichtag - and
Articles 261 (2) e) of the Law dated August 10, 1915).

4.3 The assets and liabilities transferred from Styrolution Luxembourg S. à r.l. to Styrolution Group GmbH by virtue

of the Merger shall be evaluated at fair market values in Styrolution Group GmbH's commercial law annual accounts.

5. Special Rights and Advantages (Sec. 122c subs. 2 no. 7 and no. 8 UmwG as well as Article 261 (2) f) and g) of the

Law dated August 10, 1915).

5.1 There does not exist any special rights for the shareholders and the acquiring Styrolution Group GmbH will not

grant any special rights to any shareholders or to holders of securities other than shares. There are no special measures
intended, proposed or planned to those persons.

5.2 No special benefits shall be granted to auditors of the merger plan or to members of administrative, management,

supervisory or controlling boards of any of the companies involved in the merger process. In particular, no such benefits
will be granted in connection with this Merger.

6. Consequences of the Merger for the Employees and Information on the Procedures by which any Employee Parti-

cipation Rights are to be determined (Sec. 122c subs. 2 no. 4 and 10 UmwG and Article 261 (4) b) and c) of the Law
dated August 10, 1915).

6.1 The following essential factual and legal fundamentals are of importance for the description of the consequences

of the Merger for the employees and their representative bodies as well as for the description of the measures planned
in this respect:

6.2 Employment Structure
The transferring Styrolution Luxembourg S.à r.l. has no employees. The acquiring Styrolution Group GmbH currently

(per July 31, 2014) has 88 (in words eighty eight) employees.

6.3 Works Council
Neither the transferring Styrolution Luxembourg S. à r.l. nor the acquiring Styrolution Group GmbH have a works

council or another representative body for employees. A submission of the Common Draft Terms of Cross-Border
Merger to the works council according to Sec. 122a subs. 2 in connection with Sec. 5 subs. 3 UmwG is therefore not
necessary.

6.4 Linkage to Collective Bargaining Agreements

116465

L

U X E M B O U R G

For the transferring Styrolution Luxembourg S.à r.l. no collective bargaining agreements apply. For Styrolution Group

GmbH the industry wide collective bargaining agreement of the Trade Union Mining, Chemistry, Energy (IGBCE) applies.

6.5 As Styrolution Luxembourg S.à r.l. does not have employees or a works council or another representative body

for employees, the Merger does not have any impact on employees and works councils or another representative body
for employees.

6.6 Styrolution Group GmbH shall not be affected by the Merger with regard to its contractual relationships and in

particular also to its employment contracts.

6.7 The employment structure of the business unit of Styrolution Group GmbH will not be affected by the Merger.
6.8 As a result of the Merger no employment will be created nor cancelled or changed in any way. The Merger has no

consequences for the employment.

6.9 Any further measures, which could have any consequences for the employees of Styrolution Group GmbH are

not intended in the course of the Merger.

6.10 Executive bodies and other representation rights with Styrolution Luxembourg S.à r.l. will cease to exist.
6.11 A procedure according to Sec. 122c subs. 2 no. 19 UmwG is not necessary as none of the prerequisites of Sec.

5 Act on Co-Determination of Employees in a Cross-Border Merger (MgVG) is fulfilled. In particular neither company
involved in the Merger employed more than 500 employes in the average (Sec. 5 no. 1 MgVG) in the 6 months preceding
the publication of the Common Draft Terms of Cross-Border Merger.

Besides, neither Sec. 5 no. 2 nor Sec. 5 no. 3 MgVG are relevant, as due to the lack of employees of the transferring

company no co-determination rights are existing at the time the Merger becomes effective and therefore also no co-
determination rights can get lost through the Merger.

6.12 According to Section 122e UmwG the common merger report has been made available in due time and in the

correct form.

7. Articles of Association of Styrolution Group GmbH (Sec. 122c subs. 2 no. 9 UmwG and Article 261 (4) a) of the

Law dated 10 August 1915). The Articles of Association of Styrolution Group GmbH are attached as Annex 1.

The Articles of Association of Styrolution Group GmbH shall not be amended in connection with the Merger between

Styrolution Group GmbH and Styrolution Luxembourg S.à r.l.

8. Approvals.
8.1 The Common Terms of Cross-Border Merger shall become effective as soon as the shareholder's meeting of

Styrolution Group GmbH with a majority of three quarters of the votes cast has approved the Merger Plan. The share-
holder's meeting will presumably be held on 13 October 2014.

8.2 According to German law a consent of the shareholder's meeting of Styrolution Luxembourg S.à r.l. is not required

according to Sec. 122g subs. 2 UmwG as all shares in the transferring Styrolution Luxembourg S.à r.l. are held by the
acquiring Styrolution Group GmbH. According to Luxembourg law the shareholder's meeting of Styrolution Luxembourg
S.à r.l. approving the Merger will be held in front of a Luxembourg Notary, presumably on 20 October 2014.

8.3 Other than as stipulated in these Common Draft Terms of Cross-Border Merger no other approval is required

for the Common Terms of Cross-Border Merger to become effective.

9. Merger Audit. A review of the Merger by an independent expert is not necessary according to Sec. 122 f, 9 subs.

3, 8 subs. 3 UmwG and and Articles 278 of the Law dated August 10, 1915, as all shares in the transferring Styrolution
Luxembourg S.à r.l. are held by the acquiring Styrolution Group GmbH.

10. Filing of the common draft terms on the merger (Sec. 122d UmwG and Article 262 of the Law dated 10 August

1915).

10.1 The Common Draft Terms of Cross-Border Merger will be filed with the Luxembourg Trade and Companies

Register (Registre de Commerce et des Sociétés) and published in the Luxembourg official gazette (Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations), in accordance with Article 262 and 9 of the Law dated 10 August 1915.

10.2 The Common Draft Terms of Cross-Border Merger will be filed with the commercial register of the local court

of Frankfurt am Main and published by it, in accordance with Sec. 122d UmwG.

11. The position of the creditors (Articles 262 (2) c) and 268 of the Law dated 10 August 1915).
11.1 With effectiveness of the merger the creditors of Styrolution Luxembourg S.à r.l. will become creditors of Sty-

rolution Group GmbH.

11.2 According to Article 268 of the Law dated 10 August 1915, the creditors of the merging companies, whose claims

predate  the  date  of  publication  of  the  decision  of  the  shareholders  recording  the  merger  may,  notwithstanding  any
agreement to the contrary, apply within two months after publication to the competent court to obtain adequate safeguard
of collateral for any matured and unmatured debts, where the merger would make such protection necessary.

11.3 In accordance with Article 262 (2) c) of the Law dated 10 August 1915, the creditors of Styrolution Luxembourg

S.à r.l. can obtain information on the arrangements made for the exercise of their rights:

- in Luxembourg at the following address: 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

116466

L

U X E M B O U R G

- In Germany, at the following Address: Erlenstraße 2, 60325 Frankfurt am Main.

12. Availability of the merger documentation (Article 267 (1) a), b), c) and d) of the Law dated 10 August 1915). The

documents referred to in Article 267 (1) a), b), c) and d) of the Law dated 10 August 1915, in particular:

- the Common Draft Terms of Cross-Border Merger,
- the annual accounts and the management report for the last three financial years of Styrolution Luxembourg S.à r.l.

and Styrolution Group GmbH,

- the explanatory report (merger report) of the management boards of Styrolution Luxembourg S.à r.l. and Styrolution

Group GmbH,

will be made available for the inspection of the shareholder(s) at the registered offices of the merging companies.

13. Costs.  The  costs  of  the  Common  Draft  Terms  of  Cross-Border  Merger  and  its  execution  shall  be  borne  by

Styrolution Group GmbH. In case the Merger will not become effective, each company shall bear its costs arisen in
connection with the preparation and implementation of the Merger as well as in connection with these Common Draft
Terms of Cross-Border Merger itself.

14. Miscellaneous.
14.1 Should any provision of these Common Draft Terms of Cross-Border Merger be or become ineffective, imprac-

ticable or unenforceable, the effectiveness of the other provisions shall remain unaffected. Instead, the Parties hereby
undertake to replace the ineffective, impracticable or unenforceable provision by a provision which comes as close as
legally possible to what the Parties intended from an economic point of view in accordance with the content and purpose
of the ineffective, impracticable or unenforceable provision. The same shall apply to any omissions.

14.2 Any amendments or supplements to these Common Draft Terms of Cross-Border Merger shall be made in

writing. Any amendments or supplements to the Common Terms of Cross-Border Merger shall be made through a
notarial deed.

Styrolution Luxembourg S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
satzungsmäßiger Sitz: Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg
Handelsregister von Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg), Luxemburg,
Eintragung im Handelsregister von Luxemburg wird gerade betrieben.

Styrolution Group GmbH
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
satzungsmäßiger Sitz: Frankfurt am Main, Deutschland
Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Deutschland, HRB 91762

<i>Entwurf des gemeinsamen Verschmelzungsplans

Die Geschäftsführung der Styrolution Group GmbH, Frankfurt am Main, Deutschland, sowie die Geschäftsführung der

Styrolution Luxembourg S.à r.l., Luxemburg, Luxemburg, stellen hiermit gemäß § 122c Abs. 1 und 2 UmwG sowie des
Abschnitts XIV in der geänderten Fassung des Gesetzes vom 10. August 1915 in Bezug auf Unternehmen (dem Gesetz
vom 10. August 1915,) den folgenden Entwurf des gemeinsamen Verschmelzungsplans (der Gemeinsame Verschmel-
zungsplanentwurf)  für  die  Verschmelzung  der  Styrolution  Luxembourg  S.à  r.l.  auf  die  Styrolution  Group  GmbH  (die
Verschmelzung) auf.

Die Verschmelzung ist eine grenzüberschreitende Verschmelzung und erfolgt gemäß den Bestimmungen, die in Lu-

xemburg und in der Bundesrepublik Deutschland in Umsetzung der Richtlinie 2005/56/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 26. Oktober 2005 (die Richtlinie 2005/56/EG) über die Verschmelzung von Kapitalgesellschaften aus
verschiedenen Mitgliedstaaten geschaffen wurden. In Luxemburg erfolgt die Verschmelzung gemäß des Abschnitts XIV
des Gesetzes vom 10. August 1915; in der Bundesrepublik Deutschland erfolgt die Verschmelzung gemäß den Bestim-
mungen des Zehnten Abschnitts des Zweiten Teils des Zweiten Buchs des Umwandlungsgesetzes (UmwG).

VERSCHMELZUNGSPLAN

1. Beteiligte Gesellschaften (§ 122c Abs. 2 Nr. 1 UmwG sowie Artikel 261 (2) a) des Gesetzes vom 10. August 1915);

Sonderrechte (§ 23 UmwG sowie Artikel 261 (2) f) des Gesetzes vom 10. August 1915).

1.1 Die übernehmende Gesellschaft der Verschmelzung ist die Styrolution Group GmbH, eine Gesellschaft mit be-

schränkter Haftung deutschen Rechts mit Satzungssitz in Frankfurt am Main, Deutschland, und Geschäftsadresse Erlen-
straße 2, 60325 Frankfurt am Main, welche im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB 91762
eingetragen ist.

Das Stammkapital der Styrolution Group GmbH beträgt EUR 10.000.000 (in Worten Euro zehn Millionen). Es besteht

aus 10.000.000 Geschäftsanteilen im Nominalwert von je EUR 1 (in Worten: ein Euro), auf welche die zu leistenden
Einlagen in voller Höhe bewirkt wurden.

116467

L

U X E M B O U R G

Im Übrigen bestehen bei der Styrolution Group GmbH keine Sonderrechte im Sinne von § 23 UmwG bzw. Artikel

261 (2) f) des Gesetzes vom 10. August 1915.

Die alleinige Gesellschafterin der Styrolution Group GmbH ist die Styrolution Beteiligungs GmbH mit Sitz in Frankfurt

am Main, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichs Frankfurt am Main unter HRB 91761.

1.2 Die übertragende Gesellschaft der Verschmelzung ist die Styrolution Luxembourg S.à r.l., eine Gesellschaft mit

beschränkter Haftung (Société à responsabilité limitée) gegründet und bestehend nach dem Recht des Großherzogtums
von Luxemburg mit Gesellschaftssitz in L-2453 Luxemburg, 2-4, rue Eugène Ruppert, deren Eintragung derzeit im Han-
delsregister von Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés von Luxemburg) betrieben wird.

Das Stammkapital der Styrolution Luxembourg S.à r.l. beträgt EUR 12.700 (in Worten Euro zwölftausendsiebenhun-

dert). Es ist eingeteilt in 12.700 Geschäftsanteile im Nominalwert von je EUR 1 (in Worten: ein Euro) auf die die zu
leistenden Einlagen in voller Höhe bewirkt wurden. Im Übrigen bestehen bei der Styrolution Luxembourg S.à r.l. keine
Sonderrechte im Sinne von § 23 UmwG bzw. Artikel 261 (2) f) des Gesetzes vom 10. August 1915.

Die alleinige Gesellschafterin der Styrolution Luxembourg S.à r.l. ist die Styrolution Group GmbH.

2. Vermögensübertragung, Wirkung der Verschmelzung. Die Styrolution Luxembourg S.à r.l. überträgt ihr Vermögen

als Ganzes mit allen Rechten und Pflichten unter Auflösung ohne Abwicklung auf die Styrolution Group GmbH im Wege
einer grenzüberschreitenden Verschmelzung durch Aufnahme gemäß §§ 2 Nr. 1, 46 ff., 122 a ff. UmwG und Unterabschnitt
III des Abschnitts XIV in Bezug auf Verschmelzungen des Gesetzes vom 10. August 1915. Bei der Verschmelzung handelt
es sich um eine sogenannte „Aufwärts-Verschmelzung zur Aufnahme“ wobei die 100%-ige Tochtergesellschaft auf ihre
Muttergesellschaft verschmolzen wird.

Die Verschmelzung erfolgt gemäß § 122c Abs. 3 sowie § 122a Abs. 2 iVm § 5 Abs. 2 UmwG und Artikel 278 des

Gesetzes vom 10. August 1915 ohne Gegenleistung für die Übertragung des Vermögens, da die übernehmende Gesell-
schaft sämtliche Geschäftsanteile an der übertragenden Gesellschaft hält.

Gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 2 UmwG bzw. gem. Artikel 274 des Gesetzes vom 10. August 1915, führt die Verschmelzung

zur automatischen Übertragung sämtlicher Vermögensrechte und Verbindlichkeiten der Styrolution Luxembourg S.à r.l.
auf die Styrolution Group GmbH.

Die Styrolution Luxembourg S.à r.l. wird mit dem Datum der rechtlichen Wirksamkeit (Eintragung der Verschmelzung

im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Deutschland) der Verschmelzung ipso jure aufhören zu existie-
ren.

Da die Verbindlichkeiten der Styrolution Luxembourg S.à r.l. auf die Styrolution Group GmbH übertragen werden,

wird der Auflösung der Styrolution Luxembourg S.à r.l. keine Abwicklung nachfolgen.

3. Umtauschverhältnis; Gewinnberechtigung; Barabfindung (§ 122c Abs. 2 Nr. 2, Nr. 3 und Nr. 5 UmwG sowie Artikel

261 (2) b), c) und d) des Gesetzes vom 10. August 1915). Die Styrolution Group GmbH hält alle Anteile an der Styrolution
Luxembourg S.à r.l. Eine Kapitalerhöhung ist damit nach § 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UmwG ausgeschlossen. Nach § 122c
Abs. 3 UmwG und Artikel 278 des Gesetzes vom 10. August 1915, entfallen deshalb die Angaben zum Umtausch der
Anteile nach § 122c Abs. 2 Nr. 2, Nr. 3 und Nr. 5 UmwG bzw. Artikel 278 des Gesetzes vom 10. August 1915.

4. Bilanz; Verschmelzungsstichtag; Bewertung gem. § 122 c Abs. 2 Nr. 6, Nr. 11 und Nr. 12 UmwG sowie Artikel 36

und Artikel 261 (4) d) und e) des Gesetzes vom 10. August 1915.

4.1 Der Verschmelzung werden die Bilanzen der Styrolution Luxembourg S.à r.l. zum 5. September 2014 sowie der

Styrolution Group GmbH zum 31. Dezember 2013 zugrunde gelegt.

4.2 Die in Ziffer 4.1 erwähnten Bilanzen dienen auch zur Festlegung der Bedingungen der Verschmelzung gemäß § 122c

Abs. 2 Nr. 12 UmwG bzw. Artikel 261 (4) e) des Gesetzes vom 10. August 1915.

Die Übernahme des Vermögens der Styrolution Luxembourg S.à r.l. durch die Styrolution Group GmbH erfolgt mit

schuldrechtlicher und handelsrechtlicher Wirkung zum Beginn des 6. September 2014, 0:00 Uhr. Von diesem Zeitpunkt
an gelten alle Handlungen und Geschäfte der Styrolution Luxembourg S.à r.l. als für Rechnung der Styrolution Group
GmbH vorgenommen (Verschmelzungsstichtag im Sinne von § 122c Abs. 2 Nr. 6 UmwG und Artikel 274 des Gesetzes
vom 10. August 1915).

4.3 Die Styrolution Group GmbH wird die von der Styrolution Luxembourg S.à r.l. auf sie übergehenden Vermögens-

gegenstände des Aktiv- und Passivvermögens in ihrem handelsrechtlichen Jahresabschluss bewertet zu Verkehrswerten
ansetzen.

5. Besondere Rechte und Vorteile (§ 122c Abs. 2 Nr. 7 und Nr. 8 UmwG sowie Artikel 261 (2) f) und g) des Gesetzes

vom 10. August 1915).

5.1 Es existieren keine besonderen Rechte für Gesellschafter und die übernehmende Styrolution Group GmbH wird

auch keine besonderen Rechte (Sonderrechte) für Gesellschafter oder Inhaber von anderen Wertpapieren gewähren. Es
sind auch keine besonderen Maßnahmen für solche Personen vorgesehen, vorgeschlagen oder geplant.

5.2  Es  werden  keine  besonderen  Vorteile  für  die  Sachverständigen,  die  den  Verschmelzungsplan  prüfen,  oder  für

Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs-, Aufsichtsoder Kontrollorgane einer der beteiligten Gesellschaften gewährt. Ins-
besondere werden keine derartigen Vorteile im Zusammenhang mit dieser Verschmelzung gewährt.

116468

L

U X E M B O U R G

6. Auswirkungen der Verschmelzung auf die Beschäftigung und Angaben zum Arbeitnehmerbeteiligungsverfahren zur

Festlegung von Mitbestimmungsrechten (§ 122c Abs. 2 Nr. 4 und 10 UmwG und Artikel 261 (4) b) und c) des Gesetzes
vom 10. August 1915).

6.1 Für die Beschreibung der Folgen der Verschmelzung für die Arbeitnehmer sowie die insoweit vorgesehenen Maß-

nahmen sind die folgenden wesentlichen tatsächlichen und rechtlichen Grundlagen von Bedeutung:

6.2 Beschäftigungsstruktur
Bei der übertragenden Styrolution Luxembourg S.à r.l. sind keine Arbeitnehmer beschäftigt. Die übernehmende Sty-

rolution Group GmbH beschäftigt derzeit (Stichtag 31. Juli 2014) 88 (in Worten: achtundachzig) Arbeitnehmer.

6.3 Betriebsrat:
Weder bei der übertragenden Styrolution Luxembourg S.à r.l noch bei der übernehmenden Styrolution Group GmbH

besteht ein Betriebsrat oder eine sonstige Arbeitnehmervertretung.

Eine Zuleitung des Entwurfs des Gemeinsamen Verschmelzungsplanentwurfs an den Betriebsrat gemäß § 122a Abs. 2

i.V.m § 5 Abs. 3 UmwG ist daher nicht erforderlich.

6.4 Tarifbindung
Die übertragende Styrolution Luxembourg S.à r.l. ist nicht tarifgebunden. Die übernehmende Styrolution Group GmbH

ist tarifgebunden gemäß dem Manteltarifvertrag mit der IG Bergbau, Chemie, Energie.

6.5 Da die Styrolution Luxembourg S.à r.l. weder Arbeitnehmer noch einen Betriebsrat noch sonstige Arbeitnehmer-

vertretung  hat,  hat  die  Verschmelzung  insoweit  auch  keine  Folgen  für  Arbeitnehmer  und  Betriebsräte  bzw.  sonstige
Arbeitnehmervertretungen.

6.6 Die Styrolution Group GmbH bleibt durch die Verschmelzung als Rechtsträger hinsichtlich ihrer Vertragsbezie-

hungen und insbesondere auch hinsichtlich der Arbeitsverträge unverändert.

6.7 Die arbeitsorganisatorische Struktur des Betriebes der Styrolution Group GmbH bleibt durch die Verschmelzung

ebenfalls unberührt.

6.8 Durch die Verschmelzung selbst werden weder Arbeitsplätze geschaffen noch fallen solche weg oder erfahren

irgendwelche Änderung. Die Verschmelzung hat auf die Beschäftigung keine Auswirkung.

6.9 Sonstige Maßnahmen, die etwaige Folgen für Arbeitnehmer der Styrolution Group GmbH haben könnten, sind im

Rahmen der Verschmelzung nicht vorgesehen.

6.10 Organstellungen und sonstige Vertretungsberechtigungen bei der Styrolution Luxembourg S.à r.l. erlöschen.
6.11 Ein Verfahren nach § 122c Abs. 2 Nr. 10 UmwG ist nicht erforderlich, da keine der in § 5 Gesetz über die

Mitbestimmung der Arbeitnehmer bei einer grenzüberschreitenden Verschmelzung (MgVG) genannten Voraussetzungen
erfüllt sind. Insbesondere hat keine der beiden an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften in den 6 Monaten vor
der Veröffentlichung des Gemeinsamen Verschmelzungsplanentwurfs durchschnittlich mehr als 500 Arbeitnehmer be-
schäftigt (§ 5 Nr. 1 MgVG).

Daneben sind weder § 5 Nr. 2 noch § 5 Nr. 3 MgVG einschlägig, da mangels Arbeitnehmer der übertragenden Ge-

sellschaft zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Verschmelzung keine Mitbestimmungsrechte bestehen und damit
durch die Verschmelzung auch keine Mitbestimmungsrechte verloren gehen können.

6.12 Der gemeinsame Verschmelzungsbericht wurde gemäß § 122e UmwG rechtzeitig und in der vorgeschriebenen

Form zugänglich gemacht.

7. Satzung der Styrolution Group GmbH (§ 122c Abs. 2 Nr. 9 UmwG und Artikel 261 (4) a) des Gesetzes vom 10.

August 1915). Die Satzung der Styrolution Group GmbH ist als Anlage 1 beigefügt.

Die Satzung der Styrolution Group GmbH wird im Rahmen der Verschmelzung zwischen der Styrolution Group GmbH

und der Styrolution Luxembourg S.à r.l. nicht verändert.

8. Zustimmungen.
8.1 Dieser Gemeinsame Verschmelzungsplan wird wirksam, sobald ihm die Gesellschafterversammlung der Styrolution

Group GmbH mit einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen zugestimmt hat. Die Gesellschafterver-
sammlung wird voraussichtlich am 13. Oktober 2014 abgehalten werden.

8.2 Nach deutschem Recht ist eine Zustimmung der Gesellschafterversammlung der Styrolution Luxembourg S.à r.l.

gemäß § 122g Abs. 2 UmwG nicht erforderlich, da sich alle Anteile an der übertragenden Styrolution Luxembourg S.à r.l.
in der Hand der übernehmenden Styrolution Group GmbH befinden. Nach luxemburgischem Recht wird die Gesell-
schafterversammlung der Styrolution Luxembourg S.à r.l. über die Zustimmung zur Verschmelzung vor einem Notar in
Luxemburg abgehalten, voraussichtlich am 20. Oktober 2014.

8.3 Soweit nicht in diesem Gemeinsamen Verschmelzungsplanentwurf vorgesehen, ist für das Wirksamwerden des

Gemeinsamen Verschmelzungsplanes keine weitere Zustimmung erforderlich.

9. Verschmelzungsprüfung. Eine Prüfung der Verschmelzung durch unabhängige Experten ist gem. §§ 122f, 9 Abs. 3, 8

Abs. 3 UmwG und Artikel 278 des Gesetzes vom 10. August 1915 nicht erforderlich, da sich alle Anteile an der über-
tragenden Styrolution Luxembourg S.à r.l. in der Hand der übernehmenden Styrolution Group GmbH befinden.

116469

L

U X E M B O U R G

10. Bekanntmachung des gemeinsamen Verschmelzungsplanentwurfs (§ 122d UmwG und Artikel 262 des Gesetzes

vom 10. August 1915).

10.1 Der gemeinsame Verschmelzungsplanentwurf wird gemäß Artikeln 262 und 9 des Gesetzes vom 10. August 1915

beim Handelsregister von Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés) eingereicht und im Luxemburgischen
Amtsblatt (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations) bekanntgemacht.

10.2 Der gemeinsame Verschmelzungsplanentwurf wird gemäß § 122d UmwG beim Handelsregister des Amtsgerichts

Frankfurt am Main eingereicht und von diesem veröffentlicht.

11. Die Stellung der Gläubiger (Artikel 262 (2) c) und 268 des Gesetzes vom 10. August 1915.
11.1 Mit Wirksamwerden der Verschmelzung werden die Gläubiger der Styrolution Luxembourg S.à r.l. solche der

Styrolution Group GmbH werden.

11.2 Gemäß Artikel 268 des Gesetzes vom 10. August 1915 können die Gläubiger der an der Verschmelzung beteiligten

Gesellschaften, deren Ansprüche dem Datum der Veröffentlichung der Entscheidung der Gesellschafter über die Ver-
schmelzung vorausgehen, unbeschadet anders lautender Vereinbarungen, innerhalb von zwei Monaten nach der Veröf-
fentlichung gegenüber dem zuständigen Gericht eine angemessene Sicherheitsleistung für sämtliche fälligen und nicht
fälligen Verbindlichkeiten geltend machen soweit die Verschmelzung solch einen Schutz notwendig macht.

11.3 Gemäß Artikel 262 (2) c) des Gesetzes vom 10. August 1915 können die Gläubiger der Styrolution Luxembourg

S.à r.l. zur Ausübung ihrer Rechte Informationen zu den getroffenen Vereinbarungen erhalten:

- In Luxemburg unter der folgenden Adresse: 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, Grand Duchy von Lu-

xemburg.

- In Deutschland unter der folgenden Adresse: Erlenstraße 2, 60325 Frankfurt am Main.

12. Auslegung der Verschmelzungsdokumente zur Einsichtnahme (Artikel 267 (1) a), b), c) und d) des Gesetzes vom

10. August 1915). Die Dokumente, auf welche Artikel 267 (1) a), b), c) und d) des Gesetzes vom 10. August 1915 Bezug
nimmt, insbesondere:

- der gemeinsame Verschmelzungsplanentwurf,
- die Jahresabschlüsse und die Lageberichte der letzten drei Geschäftsjahre der Styrolution Luxembourg S.à r.l. und

der Styrolution Group GmbH,

- der erläuternde Bericht (Verschmelzungsbericht) der Geschäftsführung der Styrolution Luxembourg S.à r.l. und der

Styrolution Group GmbH,

werden zur Einsichtnahme des/der Gesellschafter am Sitz der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften aus-

gelegt.

13. Kosten. Die durch diesen Gemeinsamen Verschmelzungsplanentwurf und aus seinem Vollzug entstehenden Kosten

trägt die Styrolution Group GmbH. Falls die Verschmelzung nicht wirksam werden sollte, trägt jede Gesellschaft die bei
ihr im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung der Verschmelzung sowie die bei ihr im Zusammenhang
mit diesem Gemeinsamen Verschmelzungsplanentwurf entstandenen Kosten selbst.

14. Abschließende Bestimmungen.
14.1 Sollte eine Bestimmung dieses Gemeinsamen Verschmelzungsplanentwurfs unwirksam, undurchführbar oder nicht

durchsetzbar sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt. Die Parteien
verpflichten sich vielmehr bereits jetzt, anstelle der unwirksamen, undurchführbaren oder nicht durchsetzbaren Bestim-
mung eine solche zu vereinbaren, die im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten dem am nächsten kommt, was die Parteien
nach dem Sinn und Zweck der unwirksamen, undurchführbaren oder nicht durchsetzbaren Bestimmung wirtschaftlich
gewollt haben. Gleiches gilt für etwaige Regelungslücken.

14.2 Änderungen oder Ergänzungen dieses Gemeinsamen Verschmelzungsplanentwurfs bedürfen der Schriftform. Än-

derungen oder Ergänzungen des Gemeinsamen Verschmelzungsplans bedürfen einer notariellen Urkunde.

Anlagen

Anlage 1. Satzung der Styrolution Group GmbH

SATZUNG

der Styrolution Group GmbH

§ 1. Firma und Sitz.
1.1 Die Firma der Gesellschaft lautet:
Styrolution Group GmbH
1.2 Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Frankfurt am Main.

§ 2. Gegenstand des Unternehmens.
2.1 Gegenstand des Unternehmens ist, sei es direkt oder indirekt (als Holdinggesellschaft durch das Halten und Ver-

walten von Unternehmensbeteiligungen), die Entwicklung, die Herstellung, der Vertrieb, die Vermarktung, der Verkauf

116470

L

U X E M B O U R G

und/oder andere kommerzielle Nutzung von Styrol-Monomeren, Polystyrol, Acrylnitrilbutadienstyrol, Styrolbutadienco-
polymeren und anderen auf Styrol basierenden Copolymeren, sowie Mischungen und Verbindungen aus Copolymeren.

2.2 Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die geeignet sind, den Unternehmensgegen-

stand  unmittelbar  oder  mittelbar  zu  fördern.  Sie  ist  insbesondere  berechtigt  zur  Gründung,  zum  Erwerb  oder  zur
mittelbaren  und  unmittelbaren  Beteiligung  -  auch  als  persönlich  haftende  Gesellschafterin  -  an  in-  und  ausländischen
Unternehmen dieses oder anderer Geschäftszweige sowie zur Übernahme der Geschäftsführung bei solchen Unterneh-
men. Die Gesellschaft darf im Inland und Ausland Zweigniederlassungen unter gleicher oder anderer Firma errichten.

§ 3. Stammkapital und Geschäftsanteile.
3.1 Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 10.000.000 (in Worten: zehn Millionen Euro).
3.2 Das Stammkapital der Gesellschaft ist eingeteilt in 10.000.000 Geschäftsanteile mit den laufenden Nummern 1 -

10.000.000 im Nennbetrag von jeweils EUR 1,00.

§ 4. Beginn und Dauer der Gesellschaft. Die Gesellschaft beginnt mit der Eintragung in das Handelsregister. lm lnnen-

verhältnis beginnt sie bereits am 15.04.2011. Ab diesem Zeitpunkt ist die Geschäftsführung ermächtigt, den Geschäfts-
betrieb der Gesellschaft in vollem Umfang im Rahmen des Gesellschaftszwecks aufzunehmen. Die Dauer der Gesellschaft
ist unbestimmt.

§ 5. Geschäftsjahr.  Geschäftsjahr  ist  das  Kalenderjahr.  Für  die  Zeit  vom  15.04.2011  bis  zum  31.12.2011  wird  ein

Rumpfgeschäftsjahr gebildet.

§ 6. Geschäftsführung und Vertretung.
6.1 Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer.
6.2 Die Geschäftsführer werden durch Gesellschafterbeschluss bestellt und abberufen. Bei Abschluss, Änderung oder

Beendigung von Dienstverträgen mit Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch die Gesellschafterversammlung ver-
treten.

6.3 Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft alleine. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt,

so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft
mit einem Prokuristen vertreten.

6.4 Die Gesellschafter können einen oder mehrere Geschäftsführer durch Gesellschafterbeschluss vom Verbot der

Mehrfachvertretung gemäß, § 181, 2. Alternative des Bürgerlichen Gesetzbuches befreien.

6.5  Mehrere  Geschäftsführer  sind  unbeschadet  ihrer  Vertretungsmacht  nach  außen  nur  gemeinschaftlich  zur  Ge-

schäftsführung befugt. Sie beschließen mit einfacher Mehrheit.

6.6  Die  Gesellschafterversammlung  kann  für  die  Geschäftsführung  eine  Geschäftsordnung  erlassen  und  Geschäfte

festlegen, für die die Geschäftsführung der vorherigen Zustimmung der Gesellschafterversammlung bedarf. In der Ge-
schäftsordnung  kann  die  Geschäftsführungsbefugnis  der  einzelnen  Geschäftsführer  abweichend  von  §  6.5  bestimmt
werden.

§ 7. Gesellschafterversammlung.
7.1 Die Gesellschafterversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen, von den Gesellschaftern

zu bestimmenden Ort statt.

7.2 Die Geschäftsführung beruft die Gesellschafterversammlung unter Ankündigung der Tagesordnung schriftlich mit

einer Frist von mindestens zwei Wochen ein, wobei der Tag der Absendung der Einladung und der Tag der Versammlung
nicht mitzurechnen sind. In dringenden Fällen kann die Frist verkürzt werden.

7.3 Eine ordentliche Gesellschafterversammlung findet mindestens einmal jährlich in den ersten acht Monaten oder,

wenn die Gesellschaft kleine Kapitalgesellschaft i.S.v. § 267 Abs. 1 des Handelsgesetzbuches ist, in den ersten elf Monaten
des Geschäftsjahres statt.

7.4 Die Geschäftsführung hat neben den gesetzlich vorgeschriebenen Fällen auf Verlangen eines Gesellschafters eine

außerordentliche Gesellschafterversammlung einzuberufen. In dem Verlangen ist der Zweck der Versammlung anzugeben.

7.5 Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß einberufen ist und mindestens 75%

des Stammkapitals vertreten sind. Sind weniger als 75% des Stammkapitals vertreten, ist unter Beachtung von § 7.2 eine
zweite Gesellschafterversammlung mit gleicher Tagesordnung einzuberufen. Diese ist ohne Rücksicht auf das vertretene
Stammkapital beschlussfähig, sofern darauf in der Einberufung dieser Gesellschafterversammlung hingewiesen worden ist.

7.6 Gesellschafterbeschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der Stimmrechte gefasst, sofern nicht das Gesetz eine

größere Mehrheit vorschreibt.

7.7 Über die in der Gesellschafterversammlung gefassten Beschlüsse ist, soweit sie nicht notariell beurkundet werden,

eine Niederschrift aufzunehmen, die von den Gesellschaftern zu unterzeichnen ist.

7.8 Beschlüsse können auch außerhalb von Gesellschafterversammlungen im Wege der schriftlichen Abstimmung per

Telefon, E-Mail oder mittels anderer elektronischer Kommunikationsmittel oder in Universalversammlungen unter Ver-
zicht auf alle gesetzlichen und satzungsmäßigen Einberufungsvoraussetzungen gefasst werden, wenn alle Gesellschafter
damit einverstanden sind.

116471

L

U X E M B O U R G

§ 8. Jahresabschluss.
8.1 Die Geschäftsführer haben den Jahresabschluss, bestehend aus Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung samt

Anhang und den Lagebericht innerhalb von drei Monaten nach Ende des Geschäftsjahres oder, wenn die Gesellschaft
kleine Kapitalgesellschaft i.S.v. § 267 Abs. 1 des Handelsgesetzbuches ist, innerhalb von sechs Monaten nach Ende des
Geschäftsjahres, wenn dies einem ordnungsgemäßen Geschäftsgang entspricht, für das vergangene Geschäftsjahr aufzu-
stellen und den Gesellschaftern zum Zwecke der Feststellung vorzulegen. Ist die Gesellschaft kleine Kapitalgesellschaft
i.S.v. § 267 Abs. 1 des Handelsgesetzbuches, muss ein Lagebericht nicht aufgestellt werden.

8.2 Ist der Jahresabschluss nach den gesetzlichen Vorschriften durch einen Abschlussprüfer zu prüfen, haben die Ge-

schäftsführer diesen mit dem Lagebericht und dem Prüfungsbericht unverzüglich nach Eingang des Prüfungsberichts den
Gesellschaftern vorzulegen.

8.3 Die Gesellschafter beschließen alljährlich vor Ablauf der ersten acht Monate des Geschäftsjahres oder, wenn die

Gesellschaft kleine Kapitalgesellschaft i.S.v. § 267 Abs. 1 des Handelsgesetzbuches ist, bis zum Ablauf der ersten elf Monate
des Geschäftsjahres über die Feststellung des Jahresabschlusses, die Ergebnisverwendung, die Entlastung der Geschäfts-
führer sowie über die Wahl des Abschlussprüfers, soweit die Bestellung eines Abschlussprüfers nach den gesetzlichen
Vorschriften erforderlich ist.

8.4 Liegen die Voraussetzungen für die Befreiung gemäß § 264 Abs. 3 HGB vor, wird der Jahresabschluss unter Wahr-

nehmung dieser Befreiung aufgestellt.

§ 9. Prüfungsrecht.
9.1 Die Gesellschafter können innerhalb und außerhalb einer Gesellschafterversammlung Auskunft in Angelegenheiten

der Gesellschaft verlangen sowie Bücher und Schriften der Gesellschaft einsehen.

9.2 Die Gesellschafter können dieses Recht selbst ausüben oder durch einen zur Verschwiegenheit verpflichteten

Sachverständigen ausüben lassen.

§ 10. Befreiung vom Wettbewerbsverbot. Den Gesellschaftern ist es gestattet, mit der Gesellschaft unmittelbar und

mittelbar auf jedem ihrer Tätigkeitsgebiete in Wettbewerb zu treten.

§ 11. Schriftform. Über alle Rechtsgeschäfte und Vereinbarungen zwischen der Gesellschaft und den Gesellschaftern

sowie zwischen der Gesellschaft und einem Geschäftsführer ist unverzüglich nach ihrer Vornahme eine Niederschrift
aufzunehmen.

§ 12. Teilunwirksamkeit. Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages wegen Verstoßes gegen zwin-

gendes Recht nichtig sein, so hat dies auf die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen keinen Einfluss. Die ungültigen
Bestimmungen werden durch Beschluss der Gesellschafterversammlung durch andere ihnen möglichst gleichkommende
wirksame Bestimmungen ersetzt.

§ 13. Bekanntmachungen. Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen nur im elektronischen Bundesanzeiger für

die Bundesrepublik Deutschland.

§ 14. Gründungsaufwand. Die Gesellschaft trägt die mit ihrer Gründung verbundenen Kosten und Steuern bis zum

Betrag von EUR 2.000,00 (Euro zweitausend).

Référence de publication: 2014140499/481.
(140158894) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2014.

One S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 49, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 168.631.

<i>Extrait des décisions prises par l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg, le 31 mars 2014.

L'assemblée générale extraordinaire accepte la démission de Madame Valérie Dentz comme gérant technique et nom-

me nouveau gérant technique Monsieur Christophe Bodelet, né le 23 février 1971 à Mons (Belgique), domicilié à B-6717
Nothomb, 228 Chemin des Tilleuls, à partir du 22 avril 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 02 juillet 2014.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société

Référence de publication: 2014098553/15.
(140117511) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2014.

116472

L

U X E M B O U R G

Goodman Alizarin Logistics (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 164.808.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014095899/9.
(140114727) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2014.

Goodman Peppermint Logistics (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 164.554.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014095908/9.
(140114718) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2014.

Kirchberg Asset and Investment Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 125.000,00.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 8, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 189.539.

STATUTES

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-fourth day of July.
Before the undersigned Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

- Hemstone Holding B.V., a besloten vennootschap, incorporated and existing under the laws of the Netherlands,

having its registered office at 208-214, Herengracht, NL-1016BS Amsterdam, the Netherlands, and registered with the
trade register of the Chambers of Commerce under file number 34291821,

here represented by Mrs Gaëlle Schneider, lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given

under private seal in Amsterdam, on 16 July 2014;

and
- Kingstone Investment S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand

Duchy of Luxembourg, having its registered office at 8, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg, and registered
with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 152.312,

here represented by Mrs Gaëlle Schneider, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal in Luxembourg,

on 18 July 2014.

The said proxies, initialled ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in its hereabove stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed of

incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which it wishes to organize and the
articles of association of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established by the current owner of the shares created hereafter and among all those who

may become shareholders in the future, a private limited liability company (société à responsabilité limitée) (hereinafter
the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, as well
as by the present articles of association.

Art. 2. The purpose of the Company is the creation, administration and management of one or more specialised

investment funds organized under the Luxembourg law dated 13 February 2007 relating to specialised investment funds
as it may be amended from time to time (the “SIF Law”) and the creation, administration and management of one or
more undertakings for collective investment organized under the Luxembourg law dated 17 December 2010 relating to
undertakings for collective investment, as it may be amended from time to time (the “2010 Law”) (together the “Funds”)
as well as any analogous foreign structures, within the meaning of article 125-1 of the 2010 Law.

116473

L

U X E M B O U R G

The Company shall carry out any activities connected with the management, administration, marketing and promotion

of the Funds. It may, on behalf of the Funds, enter into any contracts, purchase, sell, exchange and deliver any securities,
property and, more generally, assets constitutive of authorised investments of the Funds, proceed to or initiate any
registrations and transfers in its name or in third parties' name in the register of shares or debentures of any Luxembourg
or foreign companies, and exercise on behalf of the Funds and the holders of units of the Funds, all rights and privileges,
especially all voting rights attached to the securities constituting the assets of the Funds. The Company may further
incorporate and/or acquire shares or other securities in or issued by any of its subsidiary companies for the account of
the Funds managed or prospectively managed by it. The foregoing powers shall not be considered as exhaustive, but only
as declaratory.

The Company may also manage its own assets on an ancillary basis and may carry out any activities deemed useful for

the  accomplishment  of  its  object,  remaining,  however,  within  the  limitations  set  forth  by  the  Luxembourg  laws  and
regulations and, in particular, the provisions of article 125-1 of the 2010 Law.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period. It may be dissolved at any time and with or without

cause by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the manner required for an amendment of these
articles of association.

Art. 4. The Company will assume the name of “Kirchberg Asset and Investment Management S.à r.l.”.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg city. It may be transferred within the

municipality of Luxembourg by means of a resolution of the board of managers, and to any other municipality in the Grand
Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of its shareholders. Branches or other offices may
be established either in Luxembourg or abroad (by a resolution of the board of managers).

In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances,

natural disaster or military events have occurred or are imminent which would interfere with the normal activities of the
Company at its registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the regis-
tered  office  may  be  temporarily  transferred  abroad  by  resolution  of  the  board  of  managers  until  cessation  of  these
abnormal circumstances, such provisional measures shall have no effect on the nationality of the Company which, not-
withstanding such temporary transfer, shall remain a Luxembourg corporation.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company's share capital is set at one hundred twenty-five thousand euros (EUR 125,000.-) represented

by one thousand (1,000) shares with a nominal value of one hundred twenty five euros (EUR 125.-) each fully paid-up.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings. The shares will entitle the holders

thereof to the rights set forth in Article 23. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of
shareholders representing at least three quarters of the share capital.

Art. 7. The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
The shares of the Company are in registered form.
The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders. Death, suspension

of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of the shareholders shall not
cause the dissolution of the Company.

Art. 8. A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection

by any shareholder. This register shall contain all the information required by the law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.

Art. 9. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative

who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached
to that share until such representative has been appointed.

Art. 10. The Company's shares are freely transferable among shareholders. Any inter vivos transfer to a new partner

is subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three
quarters of the share capital.

Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of the

transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new shareholders subject to the

approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of the share
capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the
surviving spouse.

Art. 11. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the

dissolution of the Company.

116474

L

U X E M B O U R G

C. Management

Art. 12. The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers

form a board of managers.

If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not

expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of
association is to be construed as a reference to the “sole manager”.

The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any actions

necessary or useful to fulfil the Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the law of
10 August 1915 on commercial companies or by these articles of association to the general meeting of shareholders.

The managers are appointed by the sole shareholder, or as the case may be, the shareholders, who fix(es) the term

of their office and their remuneration. They may be dismissed freely at any time by the sole shareholder, or as the case
may be, the shareholders representing more than half of the Company's share capital.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of any two managers or by the individual or joint

signature(s) of any other person(s) to whom such signatory power has been delegated by a resolution of the board of
managers, as the case may be.

The board of managers may sub-delegate its powers for specific tasks to one or several ad hoc officers or agents acting

alone or jointly.

The officer's and/or agent's nomination, revocation, responsibilities and remuneration, if any, the duration of the period

of his/their representation and any other relevant conditions of his/their agency will be determined by a resolution of the
board of managers.

Art. 13. The Company is managed by a board of managers which may choose from among its members a chairman,

and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager,
who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

The board of managers shall meet upon call by any one manager at the place indicated in the notice of meeting. The

chairman shall preside all meetings of the board of managers, or in the absence of a chairman, the board of managers may
appoint another manager as chairman by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four (24) hours

in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will
not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the
board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or

facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his fellow board members.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by other

similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. Such conference-
call, video conference or similar means of communication shall be initiated from the Grand Duchy of Luxembourg. The
participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented

at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or
represented at such meeting.

Circular resolutions of the board of managers can be validly taken if approved in writing and signed by all of them in

person. Such approval may be in a single or in several separate documents sent by fax or e-mail. These resolutions shall
have the same effect as resolutions voted at the managers' meetings, duly convened. The date of such circular resolutions
shall be the date of the last signature.

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by the
board of managers.

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

In the event of vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or other-

wise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of the
replaced manager by the remaining managers until the next meeting of shareholders which shall resolve on the permanent
appointment, in compliance with the applicable legal provisions.

In case the vacancy occurs in the office of the Company's sole manager, such vacancy must be filled without undue

delay by the general meeting of shareholders.

116475

L

U X E M B O U R G

Art. 16. The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments

regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible
for the execution of their mandate.

The Company shall indemnify any manager or officer, and his heirs, executors and administrators, against expenses

reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a manager or officer of the Company, or, at its request, of any other corporation of which
the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to
matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for negligence or fault or
misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered
by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such
a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders

Art. 17. The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these

articles of association. Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which
he owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 18. Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are

adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

The shareholders may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other

amendment of the articles of association requires the approval of a majority of shareholders representing at least three
quarters of the share capital.

Art. 19. In the case of a sole shareholder, such shareholder exercises the powers granted to the general meeting of

shareholders under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise

conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case,
each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his
vote in writing.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 20. The Company's financial year commences on the 1 

st

 of January and ends on the 31 

st

 of December.

Art. 21. Each year on the 31 

st

 of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory including

an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above inventory and
balance sheet at the Company's registered office.

The accounting data reflected in the accounts and in the annual report of the Company shall be examined by an

independent auditor (réviseur d'entreprises agréé) appointed by the general meeting of shareholders and remunerated
by the Company.

Art. 22. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve.

This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten
per cent (10%) of the share capital of the Company.

Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the

contributing shareholder agrees with such allocation.

In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does not

exceed ten per cent (10%) of the share capital.

Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the re-

mainder of the Company's annual net profits shall be used in accordance with the law and these articles of association.

The net results of the Company recorded in the annual accounts, after deduction of the general expenses, amortization

and charges, constitute the distributable profit for the shares.

The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the

board of managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be
distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and
distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established
by law or by these articles of association.

Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the shareholders

subject to the provision of the law of 10 August 1915 on commercial companies and these articles of association.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

who need not be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will determine

116476

L

U X E M B O U R G

their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation
of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the

shareholders in proportion to the shares of the Company held by them.

Art. 24. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the law of

10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.

<i>Subscription and payment

The one thousand (1,000) shares, having a par value of one hundred and twenty-five Euros (EUR 125.-) each, repre-

senting the entire share capital of the Company, have been subscribed as follows:

Name of the subscriber

Number of

subscribed

shares

Value

Hemstone Holding B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

62,500 €

Kingstone Investment S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

62,500 €

All the shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of one hundred twenty-five thousand Euros

(EUR 125,000.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on 31 December

2014.

Interim dividends may be distributed during the Company's first financial year.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately EUR 1,800.-.

<i>General meeting of shareholders

The above named parties, representing the entire subscribed capital and considering themselves as fully convened, has

immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and have passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at:
8, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
2. The number of managers is fixed at 3.
3.The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
- Frank Hodyjas, born in Offenbach Am Main, Germany, on 8 January 1966, residing at 20, rue Evrard Ketten, L-1856

Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

- Floris Adriaan Dirkzwager, born in Utrecht, The Netherlands, on 27 March 1971, residing at Hoogte Kadijk 48,

1018BM Amsterdam, The Netherlands; and

- Hanna Esmee Duer, born in Gentofte, Denmark, on 7 May 1966, residing at 99, rue Centrale, 4499 Limpach, Grand

Duchy of Luxembourg.

4. Ernst &amp; Young S.A., 7, rue Gabriel Lippman, Parc d'Activité Syrdall 2, L-5365 Munsbach, Luxembourg, is elected as

independent auditor of the Company for the first financial year. The term of office of the independent auditor will end
at the general meeting approving the annual accounts closed on 31 December 2014.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing party
and in case of divergences between the English and the French text, the English version shall prevail.

The document having been read to the appearing party, known to the notary by name, first name, civil status and

residence, the said appearing party signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le vingt-quatre juillet.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

- Hemstone Holding B.V., une besloten vennootschap, constituée et régie selon les lois des Pays-Bas, ayant son siège

social au 208-214, Herengracht, NL-1016BS Amsterdam, Pays-Bas et immatriculée auprès du registre de la Chambre de
Commerce et d'Industrie sous le numéro 34291821,

116477

L

U X E M B O U R G

ici représentée par Madame Gaëlle Schneider, avocate, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une

procuration sous seing privé donnée à Amsterdam, le 16 juillet 2014;

ainsi que
- Kingstone Investment S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois du Grand-Duché

de Luxembourg, ayant son siège social au 8, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg et immatriculée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 152.312,

ici représentée par Madame Gaëlle Schneider, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à

Luxembourg, le 18 juillet 2014.

Les procurations signées «ne varietur» par la mandataire et par le notaire soussigné resteront annexées au présent

acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquelles comparantes, agissant selon la capacité décrite ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser l'acte

de constitution d'une société à responsabilité limitée qu'elles déclarent constituer et dont les statuts seront comme suit:

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes, par les associés actuels et tous ceux qui pourront devenir associés par la

suite, une société à responsabilité limitée (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. L'objet de la Société est la création, l'administration et la gestion au sens de l'article 125-1 de la Loi de 2010

d'un ou plusieurs fonds d'investissement spécialisés relevant de la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement
spécialisés, telle que modifiée de temps à autres (la «Loi FIS») et la création, l'administration et la gestion d'un ou de
plusieurs organismes de placement collectif relevant de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de place-
ment collectif, telle que modifiée de temps à autres (la «Loi de 2010») (ensemble référencés les «Fonds») ainsi que tout
autre structure étrangère similaire.

La Société pourra exercer toute activité en relation avec la gestion, l'administration, la commercialisation et la pro-

motion des Fonds. La Société pourra, pour le compte des Fonds, conclure des contrats, acheter, vendre, échanger et
livrer tous titres, propriétés, et plus généralement, tous types d'actifs constituant un investissement éligible des Fonds,
procéder à ou initier toutes inscriptions et tous transferts en son nom ou au nom de tiers dans le registre des actions
ou des obligations de toutes sociétés luxembourgeoises ou étrangères et exercer au nom des Fonds et des porteurs de
parts des Fonds tous droits et privilèges, et plus spécialement tous droits vote associés aux titres détenus par les Fonds.
La Société pourra en outre constituer et/ou acquérir des actions ou tout autre titre de, ou émis par, toutes ses filiales
pour le compte des Fonds gérés ou gérés de façon prospective par elle. L'énumération des pouvoirs ci-dessus ne se veut
pas exhaustive.

La Société peut également gérer ses propres actifs de manière accessoire et peut exercer toutes activités qu'elle jugera

utiles à l'accomplissement de son objet, dans les limites toutefois fixées par les lois et règlements luxembourgeois et, en
particulier, les dispositions de l'article 125-1 de la Loi de 2010.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée. La Société peut être dissoute à tout moment et sans

cause par une décision de l'assemblée générale des associés, prise aux conditions requises pour une modification des
présents statuts.

Art. 4. La Société prend la dénomination de «Kirchberg Asset and Investment Management S.à r.l.».

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-ville. Il peut être transféré à l'intérieur de la même localité par décision

du conseil de gérance de la Société et dans une autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des
associés de la Société prise en assemblée générale en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une
décision de l'assemblée générale des associés. Des succursales ou autres bureaux peuvent être constitués soit à Luxem-
bourg soit à l'étranger (par décision du conseil de gérance).

Au cas où le conseil de gérance, estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique, social ou

militaire ou encore catastrophe naturelle, de nature à compromettre l'activité normale de la Société au siège social ou la
communication aisée de ce siège avec des personnes à l'étranger, se sont produits ou sont imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l'étranger par décision du conseil de gérance jusqu'à cessation de ces circonstances
anormales; ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce
transfert provisoire restera une Société luxembourgeoise.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à cent vingt-cinq mille euros (EUR 125.000,-) représenté par mille (1.000)

parts sociales, d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune, entièrement libérées.

Chaque part sociale donne droit à une voix aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires. Les parts sociales

donneront droit aux associés aux droits énoncés à l'Article 23.

Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés représentant au

moins les trois quarts du capital social.

116478

L

U X E M B O U R G

Art. 7. Le capital social de la Société est divisé en parts sociales ayant chacune la même valeur nominale.
Les parts sociales de la Société sont nominatives.
La Société peut avoir un ou plusieurs associés, avec un nombre maximal de quarante (40) associés.
Le décès, la suspension des droits civils, la dissolution, la liquidation, la faillite ou l'insolvabilité ou tout autre événement

similaire d'un des associés n'entraînera pas la dissolution de la Société.

Art. 8. Un registre des parts sociales est tenu au siège social de la Société où il est mis à disposition de chaque associé

pour consultation. Ce registre contient toutes les informations requises par la loi. Des certificats d'inscription peuvent
être émis sur demande et aux frais de l'associé demandeur.

Art. 9. La Société ne reconnaîtra qu'un seul propriétaire pour chacune des parts sociales. Les copropriétaires indivis

désigneront un représentant unique qui les représentera auprès de la Société. La Société a le droit de suspendre l'exercice
de tous les droits relatifs à cette part sociale, jusqu'à ce qu'un tel représentant ait été désigné.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs

à des non-associés qu'avec l'agrément donné à ce transfert par les autres associés lors d'une assemblée générale à une
majorité des trois quarts du capital social.

Toute  cession  de  parts  sociales  est  opposable  à  la  Société  et  aux  tiers  sur  notification  de  la  cession  à,  ou  après

l'acceptation de la cession par la Société conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil.

En cas de décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que

moyennant l'agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant
aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises,
soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 11. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne cause pas à la dissolution de la

Société.

C. Gérance

Art. 12. La Société peut être gérée par un ou plusieurs gérants. Si la Société a plusieurs gérants, les gérants forment

un conseil de gérance.

Lorsque  la  Société  est  gérée  par  un  gérant  unique,  le  cas  échéant  et  lorsque  le  terme  «gérant  unique»  n'est  pas

expressément mentionné dans ces statuts, une référence au «conseil de gérance» dans ces statuts devra être entendue
comme une référence au «gérant unique».

Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société et prendre toutes actions

nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la Société, à l'exception des pouvoirs réservés par la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales ou les présents statuts à l'assemblée générale des associés.

Les gérants sont nommés par l'associé unique ou, le cas échéant, par les associés, fixant la durée de leur mandat et

leur rémunération. Ils sont librement et à tout moment révocables par l'associé unique ou, selon le cas, les associés
représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

La Société est engagée en toutes circonstances, par la signature de deux gérants ou par la signature individuelle ou

conjointe de toute(s) autre(s) personne(s) à qui des pouvoirs de signature ont été délégués par une résolution du conseil
de gérance.

Le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents

ad hoc, agissant seuls ou conjointement.

Les nomination, révocation, responsabilités, rémunération, s'il y en a une de prévue, la durée du mandat de ces agents,

ainsi que toutes autres conditions de leur mandat seront réglées par une résolution du conseil de gérance.

Art. 13. La Société est gérée par un conseil de gérance qui pourra choisir parmi ses membres un président et pourra

choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être gérant,
et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation d'un gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation. Le président

présidera toutes les réunions du conseil de gérance, et en l'absence d'un président, le conseil de gérance pourra désigner
à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant en qualité de président.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre (24) heures

avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par
écrit ou par télégraphe, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation
spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une
résolution préalable du conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par télégraphe,

télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs autres
membres du conseil de gérance.

116479

L

U X E M B O U R G

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence

ou par d'autres moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes participant à cette réunion de
s'entendre mutuellement. De telles conférences téléphoniques, vidéoconférences ou autres moyens de télécommunica-
tions devront être initiés à partir du Grand-Duché de Luxembourg. La participation à une réunion par ces moyens équivaut
à une présence en personne à une telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou

représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou
représentés à cette réunion.

Des résolutions circulaires du conseil de gérance peuvent être valablement prises si elles sont approuvées et signées

personnellement par chacun des gérants. Une telle approbation peut être donnée sur un ou plusieurs documents envoyés
par télécopieur ou par e-mail. De telles résolutions auront le même effet que des résolutions prises lors d'un conseil de
gérance dûment convoqué. La date de ces résolutions circulaires sera celle de la dernière signature.

Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son

absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux qui peuvent être produits
en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment désignée à cet
effet par le conseil de gérance.

Art. 15. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.
Dans l'hypothèse où un poste de gérant deviendrait vacant suite au décès, à l'incapacité juridique, la faillite, la démission

ou pour tout autre motif, cette vacance peut être pourvue de manière temporaire et pour une période ne pouvant
excéder celle du mandat initial du gérant remplacé par les gérants restants jusqu'à la prochaine assemblée des associés
appelée à statuer sur la nomination permanente, conformément aux dispositions légales applicables.

Dans l'hypothèse où la vacance survient alors que la Société est gérée par un gérant unique, cette vacance est comblée

sans délai par l'assemblée générale des associés.

Art. 16. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux enga-

gements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution
de leur mandat.

La Société indemnisera tout gérant ou fondé de pouvoir, ses héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs,

des dépenses raisonnablement faites par lui en rapport avec toutes actions ou tous procès auxquels il aura été partie du
fait d'être ou avoir été gérant ou fondé de pouvoir de la Société, ou à sa demande, gérant ou fondé de pouvoir de toute
autre société dont la Société est actionnaire ou créancière et par laquelle il n'aura pas droit à être indemnisé, sauf le cas
où dans pareils actions ou procès il sera finalement condamné pour négligence ou faute ou mauvaise conduite; en cas
d'arrangement extrajudiciaire, une telle indemnité relative aux matières reprises dans l'arrangement ne sera accordée
que  pour  autant  que  la  Société  est  informée  par  son  avocat-conseil  que  le  gérant  ou  fondé  de  pouvoir  devant  être
indemnisé n'a pas commis un tel manquement à ses devoirs. Ce droit à indemnisation ci-avant n'exclura pas d'autres
droits dans son chef.

D. Décisions de l'associé unique - Décisions collectives des associés

Art. 17. L'assemblée générale des associés est investie des pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la loi et

les présents statuts. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui
appartient. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.

Art. 18. Sous réserve d'un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valablement

prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social.

Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications des

statuts requièrent l'accord de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 19. Dans le cas d'un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés

selon les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Dans le cas où et aussi longtemps que la Société ne compte pas plus de vingt-cinq (25) associés, les décisions collectives

conférées à l'assemblée générale des associés peuvent être valablement prises au moyen de résolutions écrites. Dans ce
cas, chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et devra exprimer
son vote par écrit.

E. Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 20. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

Art. 21. Chaque année, le 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le conseil de gérance dresse un inventaire com-

prenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre connaissance au siège social
de la Société de l'inventaire et du bilan.

116480

L

U X E M B O U R G

Les données comptables contenues dans les comptes et dans le rapport annuel de la Société doivent être vérifiées par

un réviseur d'entreprises agréé, nommé par l'assemblée générale des associés et rémunéré par la Société.

Art. 22. Sur les bénéfices annuels nets de la Société, cinq pour cent (5%) au moins seront affectés à la réserve légale.

Cette affectation cessera d'être obligatoire dès que et tant que le montant total de la réserve légale de la Société atteindra
dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

Les sommes apportées à une réserve de la Société par un associé peuvent également être affectées à la réserve légale,

si cet associé consent à cette affectation.

En cas de réduction du capital social, la réserve légale de la Société pourra être réduite en proportion afin qu'elle

n'excède pas dix pour cent (10%) du capital social.

Sur proposition du conseil de gérance, l'assemblée générale des associés décide de l'affectation du solde des bénéfices

nets annuels distribuables de la Société conformément à la loi et aux présents statuts.

Le résultat net de la Société figurant dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissement et

charges, constitue le bénéfice distribuable pour les parts sociales.

Le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé par

le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour une distribution, étant entendu que
les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal augmenté
des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve
en vertu d'une obligation légale ou statutaire.

Toute prime d'émission, prime assimilée ou autre réserve distribuable peuvent être distribuées librement aux associés

en vertu des dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et des présents statuts.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 23. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf décision contraire, les
liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des engagements de la Société.

Le surplus résultant de la réalisation des actifs et du paiement des engagements sera partagé entre les associés en

proportion des parts sociales de la Société détenues par eux.

Art. 24. Toute matière qui n'est pas réglée par les présents statuts, sera réglée conformément à la loi du 10 août 1915

concernant les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée.

<i>Souscription et libération

Les mille (1.000) parts sociales, ayant une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune, représentant

l'intégralité du capital social de la Société, ont été intégralement souscrites de la manière qui suit:

Nom du souscripteur

Nombre

de parts

souscrites

Valeur

Hemstone Holding B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

62.500 €

Kingstone Investment S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

62.500 €

Toutes les parts souscrites ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de cent vingt-cinq mille

euros (EUR 125.000,-) est dès à présent à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2014.
Des acomptes sur dividendes pourront être distribués pendant le premier exercice social de la Société.

<i>Frais

Les frais, coûts, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société à raison de sa

constitution sont évalués à environ EUR 1.800,-.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt, les parties nommées ci-dessus, représentant l'intégralité du capital social souscrit et se considérant comme

dûment convoquées, ont tenu une assemblée générale extraordinaire et ont pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi au:
8, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
2. Le nombre de gérants est fixé à 3.
3. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Frank Hodyjas, né à Offenbach Am Main, Allemagne, le 8 janvier 1966, résidant au 20, rue Evrard Ketten, L-1856

Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

116481

L

U X E M B O U R G

- Floris Adriaan Dirkzwager, né à Utrecht, Pays-Bas, le 27 mars 1971, résidant au Hoogte Kadijk 48, 1018BM Ams-

terdam, Pays-Bas; et

- Hanna Esmee Duer, née à Gentofte, Danemark, le 7 mai 1966, résidant au 99, rue Centrale, 4499 Limpach, Grand-

Duché de Luxembourg.

4.- Ernst &amp; Young S.A., 7, rue Gabriel Lippman, Parc d'Activité Syrdall, 2, L-5365 Munsbach, Luxembourg est nommée

comme réviseur d'entreprise agréé de la Société pour la première année sociale. Son mandat prendra fin à l'assemblée
générale approuvant les comptes de la Société arrêtés au 31 décembre 2014.

Dont acte, fait passé à Luxembourg, les mêmes jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.

Et après lecture faite à la comparante, connue du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure,

la comparante a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: G. SCHNEIDER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 4 août 2014. Relation: LAC/2014/36839. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

<i>Le Receveur ff.

 (signé): C. FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 19 août 2014.

Référence de publication: 2014131346/494.
(140148752) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2014.

R.A. Investment Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 156.769.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 Décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 03 Juillet 2014.

R.A. Investment Management S.à r.l.
M.P. Galliver
<i>Manager

Référence de publication: 2014098628/14.
(140116748) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2014.

Gerana SICAV-SIF, S.A., Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécia-

lisé.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 40.859.

EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société qui s'est tenue en date du 18 juin 2014 au siège social que:
Suite à la réélection de tous les administrateurs sortants, leurs mandats se terminant lors de l'Assemblée statuant sur

les comptes de l'exercice 2014, le Conseil d'Administration se compose de:

- Raf Bogaerts, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 48 rue de Bragance, L-1255 Luxembourg;
- Michel de Groote, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 48 rue de Bragance, L-1255 Luxem-

bourg;

- Matthias Van der Looven, responsable financier, avec adresse professionnelle au 48 rue de Bragance, L-1255 Lu-

xembourg.

A été réélu comme réviseur d'entreprises agréé, son mandat prenant fin lors de l'Assemblée qui se prononcera sur

les comptes de l'exercice 2014:

- Ernst &amp; Young S.A., ayant son siège social au 7 rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2, L-5365 Munsbach.
Référence de publication: 2014098196/20.
(140116801) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2014.

116482

L

U X E M B O U R G

FD immobilier, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2560 Luxembourg, 48-50, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 170.097.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014095853/10.
(140113850) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2014.

Ferrero International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2632 Findel, rue de Trèves, Findel Business Center, Complexe B.

R.C.S. Luxembourg B 60.814.

<i>Dépôt rectificatif L1485005

La liste des signataires autorisés au 21 mai 2014 a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014095855/10.
(140113559) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2014.

DA Jupiter Lux LT Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 127.315.

A. VERSCHMELZUNGSPLAN

betreffend die Verschmelzung der
(1) Deutsche Annington Acquisition Holding GmbH mit Sitz in Düsseldorf, eingetragen im Handelsregister des Amts-

gerichts Düsseldorf unter HRB 56563

(„DA Acquisition Holding“)
und der
(2) DA Jupiter Lux LT Holdings S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Sitz in Luxemburg, Großher-

zogtum Luxemburg, eingetragen im Luxemburgischen Registre de Commerce et des Sociétés unter Nr. B 127.315

(„DA Lux LT“)

<i>Vorbemerkungen

(A) Die DA Acquisition Holding ist eine 100 %ige Tochtergesellschaft der Deutsche Annington Immobilien SE, einge-

tragen im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf unter HRB 68115 („DA Immobilien“). Das Stammkapital der DA
Acquisition Holding GmbH beträgt EUR 25.000,00 und ist voll eingezahlt.

(B) Die DA Acquistion Holding ist die alleinige Gesellschafterin der DA Lux LT. Das gesamte ausgegebene Stammkapital

dieser Gesellschaft beträgt EUR 840.966,00. Die Einlagen auf die Anteile sind vollständig erbracht.

(C) Die DA Lux LT hat keinen Grundbesitz.
(D)  Die  Parteien  beabsichtigen,  die  DA  Lux  LT  als  übertragende  Gesellschaft  auf  die  DA  Acquisition  Holding  als

übernehmende Gesellschaft nach den Vorschriften der §§ 122a ff. UmwG und Art. 257 ff. des luxemburgischen Handels-
gesetzbuchs vom 10. August 1915 in der derzeit geltenden Fassung („L-Handelsgesetzbuch“) zu verschmelzen. Als Folge
der Verschmelzung wird die DA Lux LT unter Ausschluss der Liquidation aufgelöst und sämtliche Vermögenswerte und
Verbindlichkeiten auf die DA Acquisition Holding, der alleinigen Gesellschafterin der DA Lux LT, übertragen bzw. von
dieser übernommen. Da die übernehmende DA Acquisition Holding Inhaberin sämtlicher Geschäftsanteile der übertra-
genden DA Lux LT ist,

- entfallen gemäß § 122c Abs. 3 UmwG die Angaben nach § 122c Abs. 2 Nr. 2, 3 und 5 UmwG sowie
- entfallen gemäß Art. 278 des L-Handelsgesetzbuches die Angaben nach Art. 261 (2) b), c) und d) des L-Handelsge-

setzbuches;

- sind eine Verschmelzungsprüfung und ein Prüfbericht nicht erforderlich, §§ 122f, 9 para. 3, 12 para. 3, 8 para. 3

sentence 1 UmwG; und

- sind gemäß Art. 278 des L-Handelsgesetzbuches die Informationen gemäß Art. 266 des L-Handelsgesetzbuches und

eine Verschmelzungsprüfung und ein Verschmelzungsbericht nicht erforderlich.

116483

L

U X E M B O U R G

1. Rechtsform, Firma und Sitz.
1.1 Die übertragende DA Lux LT ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts (sociétés à

responsabilitée limitée) mit Sitz in 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

1.2 Die übernehmende DA Acquisition Holding ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts mit

dem Sitz in Düsseldorf, Deutschland. Die Geschäftsadresse lautet Münsterstraße 248, 40470 Düsseldorf.

2. Vermögensübergang, Gegenleistung.
2.1 DA Lux LT als übertragende Rechtsträgerin überträgt ihr jeweiliges Vermögen als Ganzes mit allen Rechten und

Pflichten unter Auflösung ohne Abwicklung im Wege der Verschmelzung §§ 122a para. 2, 2 Nr. 1, 46 ff. UmwG, Art. 278,
257 ff. des L-Handelsgesetzbuches (Verschmelzung durch Aufnahme) auf die DA Acquisition Holding als übernehmende
Rechtsträgerin.

2.2 Die Verschmelzung erfolgt gemäß § 122a Abs. 2 i. V. m. § 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UmwG sowie Art. 278 i. V. m.

Art. 257 ff. des L-Handelsgesetzbuches ohne Gewährung von Anteilen an der übernehmenden Gesellschaft, weil die
übernehmende DA Acquisition Holding die alleinige Gesellschafterin der übertragenden DA Lux LT ist.

3. Voraussichtliche Auswirkungen der Verschmelzung auf die Beschäftigung.
3.1 Die DA Acquisition Holding und die DA Lux LT beschäftigen keine Arbeitnehmer. Weder die DA Acquisition

Holding noch die DA Lux LT haben einen beherrschenden Einfluss auf Tochtergesellschaften, in denen Arbeitnehmer
beschäftigt sind.

3.2 Weder bei der DA Acquisition Holding noch bei der DA Lux LT besteht ein Betriebsrat; auch ein Gesamt- oder

Konzernbetriebsrat oder anderweitige Arbeitnehmervertretung besteht nicht. Auch bestehen keine Vereinbarungen mit
solchen Arbeitnehmervertretungen.

3.3 Die DA Acquisition Holding und die DA Lux LT sind weder Mitglieder eines Arbeitgeberverbandes noch sind sie

unmittelbar tarifgebunden oder wenden anderweitig Tarifverträge an.

3.4 Weder in Gesellschaftsorganen der DA Acquisition Holding noch in Gesellschaftsorganen der DA Lux LT existieren

Arbeitnehmervertreter, so dass sich durch die Verschmelzung keine Auswirkungen auf die unternehmerische Mitbes-
timmung der Arbeitnehmer ergeben.

3.5 Durch die Verschmelzung werden die Rechtspositionen von Arbeitnehmern der DA Acquisition Holding, der DA

Lux LT, deren Tochtergesellschaften oder deren Vertretungen daher nicht berührt.

4. Verschmelzungsstichtag. Die Übernahme des Vermögens der DA Lux LT erfolgt im Innenverhältnis mit Wirkung

zum Ablauf des 31. Dezember 2013, 24:00 Uhr. Vom 1. Januar 2014, 0:00 Uhr, („Verschmelzungsstichtag“) an gelten alle
Handlungen und Geschäfte der DA Lux LT als für Rechnung der DA Acquisition Holding vorgenommen.

5. Besondere Rechte und Vorteile.
5.1 Besondere Rechte einzelner Anteilsinhaber der an dem Verschmelzungsvorgang beteiligten Gesellschaften oder

einzelner Inhaber anderer Wertpapiere i.S.v. § 122c Abs. 2 Nr. 7 UmwG bzw. Art. 261 (2) f) des L-Handelsgesetzbuches
werden nicht gewährt und sind daher nicht auszugleichen. Es sind auch keine besonderen Maßnahmen für diese Personen
vorgeschlagen oder vorgesehen. Daher entfallen diesbezüglich die nach § 122c Abs. 2 Nr. 7 UmwG bzw. Art. 261 (2) f)
des L-Handelsgesetzbuches vorgesehenen Angaben.

5.2 Besondere Vorteile i.S.v. § 122c Abs. 2 Nr. 8 UmwG, Art. 261 (2) g) des L-Handelsgesetzbuches werden weder

einem Mitglied eines Verwaltungs-, Leitungs-, Aufsichts- oder Kontrollorgans der an der Verschmelzung beteiligten Ge-
sellschaften  noch  einem  Abschlussprüfer  oder  sonstigen  Prüfern  oder  Sachverständigen  gewährt.  Es  sind  auch  keine
besonderen Maßnahmen für diese Person vorgeschlagen oder vorgesehen. Daher entfallen diesbezüglich die nach § 122c
Abs. 2 Nr. 8 UmwG bzw. Art. 261 (2) g) des L-Handelsgesetzbuches vorgesehenen Angaben.

6. Satzung der übernehmenden Gesellschaft. Die Firma und der Sitz der DA Acquisition Holding werden ohne Ände-

rung fortgeführt. Die Satzung der DA Acquisition Holding in der als Anlage 6 zu dieser Niederschrift beigefügten Fassung
bleibt unverändert. Auf die Anlage wird gemäß § 9 Abs. 1 Satz 2 BeurkG verwiesen.

7. Verfahren zur Beteiligung der Arbeitnehmer. Da die DA Acquisition Holding und die DA Lux LT weder mitbestimmt

sind noch Arbeitnehmer beschäftigen und auch keine Tochtergesellschaften mit Arbeitnehmer beherrschen, besteht keine
Notwendigkeit, auf Ebene der DA Acquisition Holding eine Beteiligung nach deutschem Mitbestimmungsrecht sicher-
zustellen, oder ein besonderes Verhandlungsgremium zu bilden und das Verhandlungsverfahren nach Art. L-426-13 und
Art. L-426-14261 (4) c) des luxemburgischen Arbeitsgesetzbuchs oder gemäß den Bestimmungen des deutschen Gesetzes
über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer bei einer grenzüberschreitenden Verschmelzung (MgVG) durchzuführen.

8. Angaben zur Bewertung des Aktiv- und Passivvermögens. Die Übertragung des Vermögens der DA Lux LT auf die

übernehmende DA Acquisition Holding erfolgt zu Buchwerten.

9. Stichtag der Bilanz.
9.1 Der Verschmelzung wird die Bilanz der DA Lux LT zum 31. Dezember 2013 als Schlussbilanz zu Grunde gelegt

(Anlage 9.1).

116484

L

U X E M B O U R G

9.2 Da eine Gewährung von Anteilen und eine damit verbundene Bestimmung des Umtauschverhältnisses nicht statt-

findet, entfällt eine Angabe des Bilanzstichtags der übernehmenden DA Acquisition Holding.

10. Gläubigerschutz. Gemäß Art. 268 des L-Handelsgesetzbuchs können Gläubiger der DA Lux LT, deren Ansprüche

aus der Zeit vor der Veröffentlichung der Verschmelzungsurkunden gemäß Art. 273 des L-Handelsgesetzbuchs - un-
geachtet  abweichender  Vereinbarungen  -  innerhalb  von  zwei  Monaten  nach  der  Veröffentlichung  beim  vorsitzenden
Richter der Kammer des Tribunal d'Arrondissement, zuständig für Eilverfahren in handelsrechtliche Streitigkeiten am Sitz
der Schuldnergesellschaft, beantragen, dass ihnen angemessene Sicherheiten für alle fälligen und nicht fälligen Forderungen
gestellt, soweit sie glaubhaft machen können, dass die Erfüllung ihrer Ansprüche gefährdet ist und sie von der übertra-
genden Rechtsträgerin keine angemessene Sicherheit erhalten. Der Vorsitzende des Gerichts wird den Antrag zurück-
weisen, wenn die Gläubiger bereits ausreichende Sicherheiten haben oder derartige Sicherheiten im Hinblick auf die
finanzielle Situation der aufnehmenden Gesellschaft nach der Verschmelzung nicht erforderlich sind. Die Schuldnerge-
sellschaft kann die Ablehnung des Antrags erreichen, indem sie die Forderung des Gläubigers erfüllt, auch wenn es sich
um eine befristete Verbindlichkeit handelt. Falls Sicherheiten nicht innerhalb der genannten Fristen gestellt werden, wird
die Forderung der Gläubiger sofort fällig.

Vollständige Auskünfte über die Modalitäten für die Ausübung der Rechte der Gläubiger können kostenlos eingeholt

werden bei der DA Lux LT unter: 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

11. Kosten.
11.1 Die durch den Abschluss dieses Verschmelzungsplans und seine Ausführung entstehenden Kosten, Steuern und

Gebühren trägt die DA Acquisition Holding.

11.2 Die durch die Vorbereitung dieses Verschmelzungsplans entstandenen Kosten trägt jede Vertragspartei selbst.

12. Sonstiges.
12.1  Änderungen  und  Ergänzungen  dieses  Verschmelzungsplans,  einschließlich  dieses  Absatzes,  bedürfen  zu  ihrer

Wirksamkeit der Schriftform, soweit nicht notarielle Beurkundung zwingend vorgesehen ist.

12.2 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Verschmelzungsplans unwirksam oder undurchführbar sein oder werden,

so bleiben davon die übrigen Bestimmungen unberührt. In diesem Fall gilt diejenige wirksame Bestimmung als vereinbart,
die dem von den Parteien wirtschaftlich Gewollten möglichst nahe kommt. Gleiches gilt im Falle von Regelungslücken.

A. MERGER PLAN

on the merger of
(1) Deutsche Annington Acquisition Holding GmbH with registered office in Düsseldorf, registered with the com-

mercial register of the local court of Düsseldorf under HRB 56563

(“DA Acquisition Holding”)
and the
(2) DA Jupiter Lux LT Holdings S.à r.l. a private limited liability company with its registered office in Luxembourg,

Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés under no. B
127.315

(“DA Lux LT”)

<i>Preamble

(A) DA Acquisition Holding GmbH is a 100% subsidiary of Deutsche Annington Immoblien SE, registered with the

commercial register of the local court of Düsseldorf under HRB 68115 (“DA Immobilien”). The share capital of DA
Acquisition Holding amounts to EUR 25,000.00 and is fully paid in.

(B) DA Acquisition Holding is the sole shareholder of DA Lux LT. This company's total issued share capital amounts

to EUR 840,966.00. All shares are fully paid in.

(C) DA Lux LT does not own real property.
(D) The Parties intend that DA Lux LT as transferring company shall be merged onto DA Acquisition Holding as

accepting  company  by  way  of  an  up-stream  merger  pursuant  to  Sections  122a  et  seq.  German  Transformation  Act
(UmwG) and to Art. 257 et seq. of the Luxembourg Law dated 10 August 1915 on Commercial Companies as amended
(“Law on Commercial Companies“). As a result of the merger, DA Lux LT shall be dissolved without going into liquidation
and  all  of  its  assets  and  liabilities  shall  be  transferred  to  and  assumed  by  DA  Acquisition  Holding,  which  is  the  sole
shareholder of DA Lux LT. As the acquiring DA Acquisition Holding owns all shares in the transferring DA Lux LT

- in accordance with Section 122c para. 3 UmwG, the information pursuant to Sections 122c para. 2 no. 2, 3 and 5

UmwG is not required; and

- in accordance with Art. 278 of the Law on Commercial Companies, the information pursuant to Art. 261 (2) b), c)

and d) of the Law on Commercial Companies is not required;

- an audit of the merger and an audit report are not required, Sections 122f, 9 para. 3, 12 para. 3, 8 para. 3 sentence

1 UmwG; and

116485

L

U X E M B O U R G

- in accordance with Art. 278 of the Law on Commercial Companies, the information pursuant to Art. 266 of the Law

on Commercial Companies and an audit of the merger and an audit report are not required.

1. Legal Form, Company Name and Seat.
1.1 The transferring DA Lux LT is a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under Luxem-

bourg law with its registered office in 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

1.2 The acquiring DA Acquisition Holding is a private limited liability company under German law with its seat in

Düsseldorf, Germany. The business address is Münsterstraße 248, 40470 Düsseldorf.

2. Transfer of Assets, Consideration.
2.1 DA Lux LT as transferring entity hereby transfers all of its respective assets with all rights and obligations under

dissolution without winding-up, by way of merger pursuant to Sections 122a para. 2, 2 no. 1, 46 et seq. UmwG, Art. 278,
257 et seq. of the Law on Commercial Companies (merger through acquisition) onto DA Acquisition Holding as acquiring
entity.

2.2 In accordance with Section 122a para. 2 in connection with Section 54 para. 1 sentence 1 no. 1 UmwG and Art.

278 in connection with Art. 257 et seq. of the Law on Commercial Companies the merger is effected without consider-
ation  of  shares  of  the  acquiring  company  since  the  acquiring  DA  Acquisition  Holding  is  the  sole  shareholder  of  the
transferring DA Lux LT.

3. Anticipated Effects of the Merger on Employment.
3.1 DA Acquisition Holding and DA Lux LT do not employ employees. Likewise, no employees are employed by any

subsidiaries under domination of DA Acquisition Holding or DA Lux LT.

3.2 Neither DA Acquisition Holding nor DA Lux LT has a works council; also, neither a company nor a group works

council or other employee representation is in place. Likewise, no agreements with such employee representations were
entered into.

3.3. DA Acquisition Holding and DA Lux LT are neither members of an employers' association nor are they directly

bound by any collective bargaining agreement or otherwise apply such agreements.

3.4 No employee representatives exist in corporate bodies of DA Acquisition Holding or in corporate bodies of DA

Lux LT; as a consequence the merger has no effect on the business codetermination of employees.

3.5 The legal position of employees of DA Acquisition Holding, DA Lux LT, their subsidiaries or their representations

is therefore not affected by the merger.

4. Merger Effective Date. The transfer of the assets of DA Lux LT shall be effected in the internal relationship between

the Parties with effect as of the end of 31 December 2013, 24:00 hrs. As of 1 January 2014, 0:00 hrs., (“Merger Effective
Date“) for accounting purposes all actions and business of DA Lux LT shall be deemed to be made for the account of
DA Acquisition Holding.

5. Special Rights and Advantages.
5.1 No special rights of individual shareholders of the companies participating in the merger or individual holders of

other securities within the meaning of Section 122c para. 2 no. 7 UmwG and Art. 261 (2) f) of the Law on Commercial
Companies are granted and are therefore not to be compensated. Also, no special measures for such persons have been
recommended or are anticipated. Therefore, the information pursuant to Section 122c para. 2 no. 7 UmwG, and Art.
261 (2) f) of the Law on Commercial Companies is not required.

5.2 No special advantages within the meaning of Section 122c para. 2 no. 8 UmwG, Art. 261 (2) g) of the Law on

Commercial Companies are granted to any member of the administrative, representative, supervisory or control bodies
of the companies participating in the merger, nor to any auditor or other auditors nor to any expert. Also, no special
measures have been recommended or are anticipated for these persons. Therefore, the information pursuant to Section
122c para. 2 no. 8 UmwG, and Art. 261 (2) g) of the Law on Commercial Companies is not required.

6. Articles of Association of the Acquiring Company. The company name and registered office of DA Acquisition

Holding shall be continued without changes. The articles of association of DA Acquisition Holding in the version attached
to this protocol in the Annex 6 remain unchanged. Reference is made to the Annex pursuant to Section 9 para 1 sentence
2 BeurkG.

7. Participation Proceedings of Employees. As neither DA Acquisition Holding nor DA Lux LT are co-determined or

employ employees and as also no dominated subsidiary employs employees, there is no need to organise a participation
at the level of DA Acquisition Holding post merger in accordance with German co-determination law nor to establish a
special negotiation body and carry out the negotiation procedure pursuant to Art. L-426-13 and Art. L-426-14261 (4) c)
of the Luxembourg Labour code or the German Act on Co-Determination of Employees in Case of a Cross-Border
Merger (MgVG).

8. Information regarding Valuation of Assets and Liabilities. The transfer of the assets of DA Lux LT onto the accepting

DA Acquisition Holding is made at book value.

116486

L

U X E M B O U R G

9. Effective Date of Balance Sheet.
9.1 The merger is based on the financial statement of DA Lux LT as of 31 December 2013 as final balance sheet (Annex

9.1)

9.2 As no shares are granted and no related exchange ratio exists, no information as to the balance sheet effective

date of the acquiring DA Acquisition Holding is required.

10. Creditors' Protection. Pursuant to Art. 268 and 269 of the Law on Commercial Companies, notwithstanding any

agreement to the contrary, creditors or bondholders of DA Lux LT and DA Acquisition Holding, whose claims predate
the date of publication of the document recording the merger provided for by article 273 of the Law on Commercial
Companies may, within two months following their publication, ask the judge presiding the chamber of the Tribunal
d'Arrondissement dealing with commercial matters for the district where the debtor company has its registered office
for a summary judgment requiring the establishment of guarantees for any matured or unmatured debts, provided they
can credibly prove that the merger constitutes a risk for the exercise of their rights, and that the company has not provided
them with sufficient guarantees. The president of the court will reject this request if the creditor has sufficient guarantees
available, or, if taking the company's financial situation after the merger into account, no guarantees are necessary. The
debtor company may set this request aside by paying the creditor, even if the debt is at term.

If a guarantee is not provided by the deadline fixed, the claim becomes due immediately.
Complete information on those arrangements may be obtained free of charge at DA Lux LT: 46A, avenue John F.

Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

11. Costs.
11.1 The costs, taxes and fees arising upon the execution of this Merger Plan and its performance are borne by DA

Acquisition Holding.

11.2 Each Party shall bear its own costs of the preparation of this Merger Plan.

12. Miscellaneous.
12.1 Amendments and supplements of this Merger Plan, including this paragraph, must be made in writing, except to

the extent notarization is required.

12.2 To the extent that individual provisions of this Merger Plan are or become invalid or cannot be performed, this

does not affect the validity of the other provisions. In this case such valid provision shall apply that comes closest to the
economic intentions of the Parties. The same shall apply mutatis mutandis in case of gaps.

<i>Gesellschaftsvertrag

<i>der

<i>Deutsche Annington Acquisition Holding GmbH

§1. Firma und Sitz.
1. Die Firma der Gesellschaft lautet:

Deutsche Annington Acquisition Holding GmbH

2. Sitz der Gesellschaft ist Düsseldorf,

§2. Gegenstand.
1. Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb von Vermögen und die Verwaltung eigenen Vermögens sowie von

Beteiligungen an anderen Unternehmen. Die Gesellschaft übt keine Tätigkeit aus, die einer staatlichen Genehmigung
bedarf.

2. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen

geeignet sind. Sie kann Zweigniederlassungen errichten und sich an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen.

§3. Stammkapital. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000,00 EUR (in Worten: fünfundzwanzigtausend Euro).

§4. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§5. Geschäftsführung.
1. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die

Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam
oder durch einen Geschäftsführer zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Die Gesellschafterversammlung kann
beschließen, dass auch bei Vorhandensein mehrerer Geschäftsführer einer die Gesellschaft alleinhandelnd vertreten kann.

2. Die Gesellschafterversammlung kann ferner beschließen, Geschäftsführer von den Beschränkungen des § 181 BGB

zu befreien.

§6. Jahresabschluss/Gewinnverwendung. Die Geschäftsführung hat innerhalb der gesetzlichen Frist (§ 264 HGB) den

Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang) aufzustellen und der Gesellschafterversammlung vor-
zulegen, wenn und solange die Voraussetzungen des § 264 Abs. 3 HGB nicht vorliegen.

116487

L

U X E M B O U R G

§7. Beschlussfassungen. Beschlüsse der Gesellschaftsorgane können auch unter Wahrung der Textform (im Sinne des

§ 126b BGB) herbeigeführt werden, ohne dass es der Abhaltung einer Versamlung bedarf.

§8. Bekanntmachungen. Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bundesanzeiger.

Gemäß § 54 GmbH-Gesetz bescheinige ich hiermit, dass die in dem vorstehenden Gesellschaftsvertrag der Firma

Deutsche Annington Acquisition Holding GmbH

geänderten Bestimmungen mit den in meiner Urkunde Nr. 36/2014 W vom 14. Februar 2014 gefassten Beschlüssen

über die Änderung des Gesellschaftsvertrages sowie die unveränderten Bestimmungen mit dem zuletzt zum Handelsre-
gister eingereichten vollständigen Wortlaut des Gesellschaftsvertrages übereinstimmen.

Bochum, den 14. Februar 2014.

Dr. Volker Weinreich
<i>Notar

Hiermit beglaubige ich die Übereinstimmung, der in dieser Datei enthaltenen Bilddaten (Abschrift) mit dem mir vor-

liegenden Papierdokument (Urschrift).

Bochum, den 21.02.2014.

Dr. Volker Weinreich
<i>Notar

<i>DA Jupiter Lux LT Holdings S.à r.l.

<i>(vormals DeWAG LT Holdings S.à r.l.)

46A, avenue JF Kennedy

L-1855 LUXEMBOURG

R.C.S. Luxembourg: B 127.315

<i>Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013

ANLAGENVERZEICHNIS

Seite

Anlage 1

Bilanz zum 31. Dezember 2013

Anlage 2

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftjahr vom 1. Januar 2013 bis zum
31. Dezember 2013

Anlage 3

Anhang zum Jahresabschluss 2013

Anlage 4

Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten zum Jahresabschluss 2013

<i>Verkürzte Bilanz

<i>Geschäftsjahr vom 1. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2013

<i>(in EUR)

AKTIVA

Geschäftsjahr

Voriges

Geschäftsjahr

A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital

-

-

I. davon nicht eingefordert

-

-

II. davon eingefordert aber noch nicht eingezahlt

-

-

B. Aufwendungen für die Errichtung und Erweiterung des Unternehmens

-

-

C. Anlagevermögen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 703 203,07 3 131 053,07
I. Immaterielle Anlagewerte

-

II. Sachanlagen

-

III. Finanzanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 703 203,07 3 131 053,07
D. Umlaufvermögen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11 703,41

14 456,54

I. Vorräte

-

-

II. Forderungen
a) mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 716,52

3 716,52

b) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

-

-

III. Wertpapiere

-

-

IV. Guthaben bei Kreditinstituten, Postscheckguthaben, Schecks und
Kassenbestand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 986,89

10 740,02

E. Rechnungsabgrenzungsposten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 040,34

1 329,00

116488

L

U X E M B O U R G

SUMME (AKTIVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 716 946,82 3 146 838,61
PASSIVA
A. Eigenkapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

154 960,17

314 836,49

I. Gezeichnetes Kapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

840 966,00

840 966,00

II. Ausgabeagio und vergleichbare Agien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84 095,00

84 095,00

III. Neubewertungsrücklagen

-

-

IV. Rücklagen

-

-

V. Ergebnisvortrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(610 224,51)

(485 839,78)

VI. Ergebnis des Geschäftsjahres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(159 876,32)

(124 384,73)

VII. Vorabdividenden

-

-

VIII. Subventionen in Kapitalform

-

-

IX. Immunisierter Mehrwert

-

-

B. Untergeordnete Verbindlichkeiten

-

-

C. Rückstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18 888,75

26 675,00

D. Nicht nachrangige Verbindlichkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 543 097,90 2 805 327,12
a) mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76 112,82

79 394,43

b) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 466 985,08 2 725 932,69
E. Rechnungsabgrenzungsposten

-

-

SUMME (PASSIVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 716 945,82 3 146 838,61

<i>Verkürzte Gewinn- und Verlustrechnung

<i>Geschäftsjahr vom 1. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2013

<i>(in EUR)

A. AUFWENDUNGEN

Geschäftsjahr

Voriges

Geschäftsjahr

1. Materialaufwand

-

-

2. Sonstige externe Aufwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75 071,14

59 986,67

3. Personalaufwand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22 636,39

20 421,95

a) Löhne und Gehälter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19 082,60

16 608,97

b) Soziale Aufwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 439,25

1 815,60

c) Altersversorgung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 114,54

1 997,38

d) Sonstige soziale Aufwendungen

-

-

4. Wertberichtigungen

-

-

a) zu Errichtungs- und Erweiterungsaufwendungen und zu Sachanlagen und
immateriellen Anlagewerten

-

-

b) zu Vermögensgegenständen des Umlauftvermögens

-

-

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen

-

-

6. Wertberichtigungen und Anpassungen auf den niedrigeren beizulegenden Zeitwert
der Finanzanlagen

-

-

7. Wertberichtigungen und Anpassungen auf den niedrigeren beizulegenden
Zeitwert des finanziellen Umlaufvermögens, Verluste aus dem Abgang
von Wertpapieren

-

-

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

181 052,39

173 417,79

a) davon an verbundene Unternehmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

181 052,39

173 417,79

b) sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen

-

-

9. Ausserordentliche Aufwendungen

-

-

10. Steuern auf das Ergebnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 210,00

1 575,00

11. Sonstige Steuern, soweit nicht unter obigem Posten enthalten . . . . . . . . . . . . . . .

25,00

25,00

12. Gewinn des Geschäftsjahres

-

-

SUMME AUFWENDUNGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

281 994,92

255 346,41

B. ERTRÄGE
1. bis 5. Betriebliche Erträge

-

-

6. Erträge aus Finanzanlagen

-

-

a) davon aus verbundenen Unternehmen

-

-

b) sonstige Erträge aus Beteiligungen

-

-

116489

L

U X E M B O U R G

7. Erträge aus finanziellem Umlaufvermögen

-

-

a) davon aus verbundenen Unternehmen

-

-

b) sonstige Erträge

-

-

8. Sonstige Zinsen und finanzielle Erträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122 118,60

129 063,52

a) davon aus verbundenen Unternehmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122 118,60

129 063,52

b) sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

-

-

9. Ausserordentliche Erträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

1 898,16

10. Verlust des Geschäftsjahres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

159 876,32

124 384,73

SUMME ERTRÄGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

281 994,92

255 346,41

Anhang zum Jahresabschluss 2014

1. Allgemeines. DeWAG LT Holdings S.à r.l. (im Folgenden “Die Gesellschaft“) wurde am 10. April 2007 in Form einer

Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts (Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesell-
schaften) auf unbegrenzte Zeit gegründet.

Mit Gesellschafterbeschluss vom 18. April 2014 firmierte die Gesellschaft in DA Jupiter Lux LT Holdings S.à.r.l. um.
Der Gesellschaftssitz befindet sich L-1855 Luxembourg, 46A, avenue JF Kennedy.
Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember.
Die Haupttätigkeit der Gesellschaft besteht in der Akquisition, Beteiligung und Verwaltung von luxemburgischen und/

oder ausländischen Gesellschaften.

Die Gesellschaft kann Finanzierungshilfen jeglicher Art an verbundene Unternehmen erbringen, insbesondere durch

Ausleihungen, Bürgschaften oder Gewährleistungen.

Die Gesellschaft kann jede Tätigkeit zur Erfüllung ihres Zweckes im Rahmen des anwendbaren Luxemburgischen Rechts

ausüben.

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss des „The Archstone German Fund“ einbezogen, die gleichzeitig den

grössten und den kleinsten Kreis der Unternehmen bildet, dem die Gesellschaft als Tochtergesellschaft angehört. Der
Sitz dieser Gesellschaft befindet sich 46A, avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg gelegen und der Konzernabschluss
steht in diesen Geschäftsräumen zur Verfügung.

2. Bewertungsgrundsätze, -regeln und -methoden.

Allgemeine Grundsätze
Der Jahresabschluss ist gemäss den in Luxemburg geltenden Gesetzen und Verordnungen aufzustellen. Die Rech-

nungslegungspolitik  und  die  Bewertungsgrundsätze  werden,  abgesehen  von  den  gesetzlichen  Vorschriften,  von  der
Geschäftsführung festgelegt.

Die Präsentation des Jahresabschluss wurde geändert, um der Berichtigung des Rechnungslegungsgesetz vom 10. De-

zember 2010 nachzukommen.

Die Gesellschaft hat Schätzungen vorgenommen sowie Annahmen getroffen, welche die Vermögenslage des nachfol-

genden Geschäftsjahres beeinflussen. Schätzungen und Beurteilungen werden ständig weiterentwickelt und stützen sich
auf Erfahrungen der Vergangenheit sowie auf andere Gesichtspunkte, u.a. Erwartungen bezüglich zukünftiger Ereignisse,
die vor dem gegebenen Hintergrund als angemessen erscheinen.

Wesentliche Bewertungsregeln
Die Bilanz der Gesellschaft wird in Euro präsentiert.
Anteile an verbundenen Unternehmen werden zu Anschaftungskosten bewertet und die Ausleihungen an verbundene

Unternehmen werden zum Nennwert angesetzt. Bei Wertminderungen, die nach Ansicht der Geschäftsführung dauerhaft
sind, werden diese Finanzanlagen wertberichtigt, um sie mit dem niedrigeren Wert anzusetzen der ihnen am Bilanzstichtag
beizulegen ist. Diese Wertberichtigungen werden nicht beibehalten, wenn die Gründe der Wertberichtigung nicht mehr
bestehen.

Die Forderungen werden mit ihrem Nennwert angesetzt. Sie werden wertberichtigt, wenn ihre Einziehung gefährdet

ist. Diese Wertberichtigungen werden nicht beibehalten, wenn die Gründe der Wertberichtigung nicht mehr bestehen.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten die vor dem Abschlussstichtag gebuchten Ausgaben, die ein späteres

Geschäftsjahr betreffen.

Rückstellungen dienen zur Deckung von Verlusten oder Verbindlichkeiten, die ihrer Eigenart nach genau bestimmt

sind, aber am Bilanzstichtag warscheinlich oder sicher sind, aber hinsichtlich ihrer Höhe oder dem Zeitpunkt ihres Eintritts
unbestimmt  sind.  Die  Steuerrückstellungen  entsprechen  dem  Unterschiedsbetrag  zwischen  den  von  der  Gesellschaft
berechneten Steueraufwendungen und den geleisteten Vorauszahlungen für die entsprechenden Geschäftsjahre, für die
kein endgültiger Steuerbescheid ergangen ist.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

116490

L

U X E M B O U R G

3. Finanzanlagen. Die Gesellschaft besitzt eine Beteiligung in Höhe von 100% an der Gesellschaft DAIG 11. Objektge-

sellschaft B.V. (vormals DeWAG 11. Objektgesellschaft B.V.), Vondelstraat 73, NL-1054 GK Amsterdam, deren Buchwert
EUR 990,000 (2012: EUR 990,000) beträgt, davon sind Einlagen in Höhe von EUR 72,000 (2012: EUR 72,000) austehend
und nicht eingefordet. DAIG 11. Objektgesellschaft B.V. weist im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 ein Eigenkapital
von EUR 13,121,763 (2012. EUR 17,062,272) aus und ein Verlust des letzten Geschäftsjahres von EUR 3,940,509 (Verlust
in 2012: 3,552,393). Der Jahresabschluss wurde gemäß den Bestimmungen der niederländischen Rechnungslegungsvors-
chriften aufgestellt.

Es bestehen Ausleihungen gegenüber der Tochtergesellschaft in Höhe von EUR 710,471 (2012: EUR 2,138,353), deren

Nominalwert von EUR 686,504 (2012: 2,032,993) mit 9% verzinst wurde.

Eine Kaution in Höhe von EUR 2,732 (2012: EUR 2,700) für die Büroräume wurde vom Betreiber des Geschäftszen-

trums einbehalten.

4. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben

eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr und betreffen eine Forderung gegenüber das Steueramt.

5. Gezeichnetes Kapital. Das gezeichnete Gesellschaftskapital beläuft sich auf EUR 840,966 und wird durch 840,966

Gesellschaftsanteile mit einem einheitlichen Nominalwert von EUR 1 repräsentiert.

6. Ergebnisverwendung. Der Verlustvortrag zum 31. Dezember 2013 in Höhe von EUR 610,225 und der Verlust des

Geschäftsjahres 2013 von EUR 159,876 ergeben einen Bilanzverlust von EUR 770,101. Der Bilanzverlust wird auf neue
Rechnung vorgetragen.

7. Rückstellungen.  Die  Rückstellungen  betreffen  Rückstellungen  für  Beratungskosten  von  EUR  9,689  (2012:  EUR

20,000), Abschluss- und Prüfungskosten von EUR 5,400 (2012: EUR 2,850), Aufsichts-, Depot- und Verwaltungsgebühren
von EUR 3,800 (2012: EUR 3,600).

8. Verbindlichkeiten. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr betreffen Verbindlichkeiten

gegenüber  verbundenen  Unternehmen  von  EUR  1,466,985  (2012:  EUR  2,725,933),  deren  Nominal  Wert  von  EUR
1,413,894 (2012: EUR 2,625,973) mit 8,75% verzinst wurde.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr beinhalten nicht eingeforderte Einlagen der Toch-

tergesellschaft von EUR 72,000 (2012: EUR 72,000), sowie Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von EUR
4,113 (2012: EUR 6,887).

9. Sonstige externe Aufwendungen. Die sonstigen externen Aufwendungen stellen sich wie folgt auf:

2013

EUR

2012

EUR

Rechts- und Beratungskosten: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,617 21,080
Aufsichts-, Depot- und Verwaltungsgebühren: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,094 14,499
Abschluss- und Prüfungskosten: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,487 10,793
Mieten und Nebenkosten: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8,679

8,345

Marketing- und Kommunikationskosten: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,399

1,058

Sonstige Honorare: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

502

445

Kontogebühren: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

224

1,074

Büroausstattung: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69

155

Buchführungskosten: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

2,458

75,071 59,907

10. Personal. Unterjährig beschäftigte die Gesellschaft einen Teilzeitarbeitnehmer.
Die Löhne und Gehälter beinhalten Grundlöhne in Höhe von EUR 16,802 (2012: EUR 14,339) und sonstige Zulagen

wie Essengutscheine, Zusatzkrankenversicherung, Miete der Wohnung des Arbeitnehmers, von insgesamt EUR 2,281
(2012: EUR 2,270).

11. Steuern auf das Ergebnis. Die Steuern auf das Ergebnis beziehen sich auf die Mindestbesteuerung des Einkommen.

12. Sonstige Steuern. Die sonstigen Steuern beinhalten die Vermögensteuer für 2013.

13. Ausserordentliche Erträge. Die ausserordentlichen Erträge beziehen sich aus Aufsichts-, Depot- und Verwaltungs-

gebühren, die in 2010 und 2011 an die Gesellschaft mit zu viel Mehrwertsteuer belastet wurde.

14. Geschäftsführung. Seit dem 27. Juni 2007, Bernhard Rentschler, beruflich wohnhaft 46A, avenue JF Kennedy, L-1855

Luxembourg.

Vom 26. August 2009 bis zum 27. Februar 2013, Dana Hamilton, beruflich wohnhaft Vondelstraat 73, 1054 GK Ams-

terdam, Niederlande, ersetzt zu diesem Datum durch Jochen Krauss, beruflich wohnhaft 46A, avenue JF Kennedy, L-1855
Luxembourg. Am 31. März 2014 wurde Jochen Krauss von Hans-Joachim Härtling, beruflich wohnhaft 44, Falkenstrasse,
14532 Stahndorf, Deutschland, ersetzt.

116491

L

U X E M B O U R G

15. Sonstige Information. Laut Artikel 69 des Gesetzes vom 10. Dezember 2010, ist die Gesellschaft nicht verpflichtet,

sich durch einen oder mehrere Wirtschaftsprüfer prüfen zu lassen. Deshalb wurde kein Prüfungsantrag gemacht und kein
Prüfungsbericht wurde erstellt.

Luxembourg, den 25. Juni 2014.

DA Jupiter Lux LT Holdings S.à r.l.
Hans-Joachim Härtling / Bernhard Rentschler
<i>Geschäftsführung

<i>Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten zum Jahresabschluss 2013

<i>Verkürzte Bilanz

<i>(in EUR)

AKTIVA

Geschäftsjahr

Voriges

Geschäftsjahr

A. Ausstehende Einlagen auf des gezeichnete Kapital

-

-

B. Aufwendungen für die Errichtung und Erweiterung des Unternehmens

-

-

C. Anlagevermögen
Finanzanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 703 203,07 3 131 053,07
Zusammensetzung:
Anteils an verbundenen Unternehmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

990 000,00

990 000,00

Ausleihungen an verbundene Unternehmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

686 503,60 2 032 993,37

Aufgelaufene Zinsen auf Ausleih, an verbundene Unternehmen . . . . . . . . . . . . . . . . .

23 967,67

105 359,30

Kautionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 731,80

2 700,40

1 703 203,07 3 131 053,07

D. Umlaufvermögen
Forderungen
a) mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 716,52

3 716,52

Zusammensetzung:
Steuerverwaltung - Direkte Steuern (ACD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 716,52

3 716,52

Guthaben bei Kreditinstituten, Postscheckguthaben, Schecks und Kassenbestand . . .

7 986,89

10 740,62

Zusammensetzung:
Kontokorrentkonten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 986,89

10 740,02

E. Rechnungsabgrenzungsposten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 040,34

1 329,00

Zusammensetzung:
Miet- und Nebenkosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 040,34

1 279,03

Sonstige Personalzulagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

49,97

2 040,34

1 329,00

PASSIVA
A. Eigenkapital

-

-

B. Untergeordnete Verbindlichkelten

-

-

C. Rückstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18 888,75

26 675,00

Zusammensetzung:
Rückstellungen für Aufsichts-, Depot- und Verwaltungsgebühren . . . . . . . . . . . . . . . .

3 800,00

3 600,00

Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 400,00

2 850,00

Rückstellungen für Beratungskosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9 688,75

20 000,00

Rückstellungen für Reisekosten Arbeitnehmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

200,00

Vermögenssteuerrückstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

25,00

18 888,75

26 675,00

D. Nicht nachrangige Verbindlichkeiten
a) mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76 112,82

79 394,43

Zusammensetzung:
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72 000,00

72 000,00

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 112,82

6 886,59

Verbindlichkeiten gegenüber der Sozialversicherungsanstalt (CCSS) . . . . . . . . . . . . . .

-

507,84

76 112,82

79 394,43

b) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 466 985,08 2 725 932,69

116492

L

U X E M B O U R G

Zusammensetzung:
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 466 985,08 2 725 932,69
E. Rechnungsabgrenzungsposten

-

-

<i>Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten zum Jahresabschluss 2013

<i>Verkürzte Gewinn- und Verlustrechtung

<i>(in EUR)

AUFWENDUNGEN

Geschäftsjahr

Voriges

Geschäftsjahr

1. Materialaufwand

-

-

2. Sonstige externe Aufwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75 071,14

59 906,67

Zusammensetzung:
Rechts- und Beratungskosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34 616,68

21 080,42

Aufsichts-, Depot- und Verwaltungsgebühren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17 094,32

14 499,09

Abschluss- und Prüfungskosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12 487,03

10 792,42

Mieten und Mietnebenkosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 679,05

8 344,76

Marketing- und Kommunikationskosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 398,98

1 057,95

Sonstige Honorare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

501,84

445,19

Kontogebühren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

224,20

1 074,20

Büroausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69,04

154,77

Buchführungskosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

2 457,87

75 071,14

59 906,67

3. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19 082,60

16 608,97

Zusammensetzung:
Grundlöhne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16 801,58

14 338,57

Sonstige Zulagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 281,02

2 270,40

19 082,60

16 608,97

b) Soziale Aufwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 439,25

1 815,60

Zusammensetzung:
Soziale Aufwendungen für Arbeitnehmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 439,25

1 815,60

c) Altersversorgung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 114,54

1 997,38

Zusammensetzung:
Beiträge für externe Rentenfonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 762,12

1 664,48

Einbehaltene Steuer auf Zusatzrente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

352,42

332,90

2 114,54

1 997,38

4. Wertberichtigungen

-

-

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen

-

-

6. Wertberichtigungen und Anpassungen auf den niedrigeren beizulegenden Zeitwert
der Finanzanlagen

-

-

7. Wertberichtigungen und Anpassungen auf den niedrigeren beizulegenden Zeitwert
des finanziellen Umlaufvermögens. Verluste aus dem Abgang von Wertpapieren

-

-

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

181 052,39

173 417,79

Zusammensetzung:
Zinsen auf Verbindlichkeiten gg verbundenen Unternehmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

181 052,39

173 417,79

9. Ausserordentliche Aufwendungen

-

-

10. Steuern auf das Ergebnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 210,00

1 575,00

Zusammensetzung:
Körperschaftsteuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 210,00

1 575,00

11. Sonstige Steuern, soweit nicht unter obigem Posten enthalten . . . . . . . . . . . . . . .

25,00

25,00

Zusammensetzung:
Vermögenssteuer - laufendes Geschäftsjahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25,00

25,00

ERTRÄGE
1. bis 5. Betriebliche Erträge

-

-

6. Erträge aus Finanzanlagen

-

-

116493

L

U X E M B O U R G

7. Erträge aus finanziellem Umlaufvermögen

-

-

8. Sonstige Zinsen und finanzielle Erträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122 118,60

129 063,52

Zusammensetzung:
Zinsen auf Forderungen gegen verbundene Unternehmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122 118,60

129 063,52

9. Ausserordentliche Erträge

-

1 898,16

Zusammensetzung:
Sonstige andere ausserordentliche Erträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

1 898,16

Référence de publication: 2014138889/583.
(140157867) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2014.

Finnovation S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 42, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 137.928.

1. Monsieur Yves Baguet a démissionné du Conseil d’Administration le 04 octobre 2013.
2. Monsieur Marcus Thompson a démissionné du Conseil d’Administration le 01 novembre 2013.
3. Monsieur Jürg Spillmann a démissionné du Conseil d’Administration le 03 février 2014.
4. Il résulte ce qui suit du Procès-verbal de la résolution de l'actionnaire unique de Finnovation S.A. du 28 octobre

2013:

La personne suivante a été élue au Conseil d’Administration pour un mandat de 6 ans:
Mandat prenant effet le 01 novembre 2013 pour:
- Marco Steeg 61, Mergenthalerallee D - 65760 Eschborn
5. Il résulte ce qui suit du Procès-verbal de la résolution de l'actionnaire unique de Finnovation S.A. du 29 novembre

2013:

La personne suivante a été élue au Conseil d’Administration pour un mandat de 6 ans:
Mandat prenant effet le 29 novembre 2013 pour:
- Richard Green 42, Avenue JF Kennedy L - 1855 Luxembourg
6. Il résulte ce qui suit du Procès-verbal de la résolution de l'actionnaire unique de Finnovation S.A. du 04 février 2014:
La personne suivante a été élue au Conseil d’Administration pour un mandat de 6 ans:
Mandat prenant effet le 04 février 2014 pour:
- Uwe Schweickert 61, Mergenthalerallee D - 65760 Eschborn
7. Il résulte ce qui suit du Procès-verbal de la résolution de l'actionnaire unique de Finnovation S.A. du 25 avril 2014:
La personne suivante a été élue au Conseil d’Administration pour un mandat de 6 ans:
Mandat prenant effet le 30 avril 2014 pour:
- René Keller 61, Mergenthalerallee D - 65760 Eschborn
Le Conseil d’Administration est actuellement composé des membres suivants:
- Uwe Schweickert 61, Mergenthalerallee D - 65760 Eschborn
- René Keller 61, Mergenthalerallee D - 65760 Eschborn
- Marco Steeg 61, Mergenthalerallee D - 65760 Eschborn
- Richard Green 42, Avenue JF Kennedy L - 1855 Luxembourg
- Gabriele Fabry 42, Avenue JF Kennedy L - 1855 Luxembourg
8. En date du 04 octobre 2013, Monsieur Yves Baguet a démissionné de son poste de délégué à la gestion journalière.
9. Le Conseil d’Administration du 13 décembre 2013 a nommé la personne suivante au poste de délégués à la gestion

journalière prenant effet le 13 décembre 2013:

- Richard Green 42, Avenue JF Kennedy L - 1855 Luxembourg
Les délégués à la gestion journalière sont actuellement:
- Michèle Bierset 42, Avenue JF Kennedy L - 1855 Luxembourg
- Richard Green 42, Avenue JF Kennedy L - 1855 Luxembourg.

Luxembourg, le 02 juillet 2014.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014095840/44.
(140113748) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2014.

116494

L

U X E M B O U R G

White Star S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 182.927.

L'an deux mille quatorze, le quatre juillet.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

Madame Peggy Simon, employée privée, demeurant professionnellement à L-6475 Echternach, 9, Rabatt,
agissant en sa qualité de mandataire de:
(1) Kors Trust, une fiducie (trust) établie selon les lois de l'Île de Man, dont le siège social est établi au International

House, Castle Hill, Victoria Road, Douglas, Île de Man IM2 4RB, dûment représentée par sa fiduciaire (trustee), First
Names Trust Company (Isle of Man) Limited (l'Associé 1),

(2) White and Green Holding AG, une société par actions (joint stock company) existante selon les lois d'Autriche,

dont le siège social est établi au Salztorgasse 6-8 1010, Vienne (l'Associé 2),

en vertu de deux procurations sous seing privé lui données le 19 décembre 2013,
lesquelles procurations sont restées annexées à un acte d'assemblée générale extraordinaire reçu par le notaire ins-

trumentant en date du 20 décembre 2013, numéro 13/29.089 de son répertoire, enregistré à Echternach, le 23 décembre
2013, Relation ECH/2013/2512.

Lesquels comparants, par leur mandataire, déclarent être les seuls associés de White Star S.à r.l., une société à res-

ponsabilité limitée existante et organisée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social est établi au
65 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 182.927,

I.- Attendu que, par le prédit acte du 20 décembre 2013 (L140002397), le capital social de la société a été augmenté

par un montant de deux cent trente-sept mille cinq cents euros (EUR 237.500,-) afin de porter le capital social de la
Société de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales,
ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, à deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000,-) représenté
par deux cent cinquante mille parts sociales (250.000) par voie d'émission de deux cent trente-sept mille cinq cents
(237.500) nouvelles parts sociales, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune.

II.- Attendu que lors de la souscription-libération, l'Associé 1 avait souscrit à 11.875 (onze mille huit cent soixante-

quinze) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune et les avait libéré intégralement
par un apport en nature consistant en une créance qu'il détient représentant un montant total de trois millions quatre
cent vingt-quatre mille six cent quatre-vingt-trois euros et cinquante centimes (EUR 3.424.683,50) (la Créance 1), qui
avait été affecté comme suit:

- un montant de onze mille huit cent soixante-quinze euros (EUR 11.875) au compte de capital social de la Société; et
- un montant de trois millions quatre cent douze mille huit cent sept euros et cinquante cents (EUR 3.412.807,50) au

compte de prime d'émission de la Société relié aux parts sociales.

Or il s'est avéré que le montant qui aurait dû être alloué au compte de prime d'émission doit être de trois millions

quatre cent douze mille huit cent huit euros cinquante cents (EUR 3.412.808,50)

III.- Attendu que lors de la souscription-libération, l'Associé 2 avait souscrit à 225.125 (deux cent vingt-cinq mille cent

vingt-cinq) nouvelles parts sociales, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune et les avait libéré intégralement
par un apport en nature consistant en une créance qu'il détient représentant un montant total de soixante-cinq millions
soixante-huit mille neuf cent quatre-vingt-six euros et cinquante centimes (EUR 65.068.986,50) (la Créance 2) qui doit
être affecté comme suit:

- un montant de deux cent vingt-cinq mille cent vingt-cinq euros (EUR 225.125) au compte de capital social de la

Société; et

- un montant de soixante-quatre millions huit cent quarante-trois mille huit cent soixante et un euros et cinquante

centimes (EUR 64.843.861,50) au compte de prime d'émission de la Société relié aux parts sociales.

Or il s'est avéré que l'Associé aurait dû souscrire à 225.625 (deux cent vingt-cinq mille six cent vingt-cinq) et les libérer

moyennant un apport en nature consistant en une créance qu'il détient représentant un montant total de soixante-cinq
millions soixante-huit mille neuf cent quatre-vingt-six euros et cinquante centimes (EUR 65.068.986,50) (la Créance 2)
qui doit être affecté comme suit:

- un montant de deux cent vingt-cinq mille six cent vingt-cinq euros (EUR 225.625) au compte de capital social de la

Société; et

- un montant de soixante-quatre millions huit cent quarante-trois mille trois cent soixante et un euros et cinquante

cents (EUR 64.843.361,50) au compte de prime d'émission de la Société relié aux parts sociales.

IV.- Attendu qu'il y a également lieu de rectifier dans la quatrième résolution du prédit acte l'affectation du compte de

prime d'émission de la Société, à savoir:

116495

L

U X E M B O U R G

- un montant de trente-quatre millions cent vingt-huit mille quatre-vingt-cinq euros (EUR 34.128.085,-) au Compte de

Prime d'Emission des Parts Sociales Traçantes A au lieu du montant de trente-quatre millions deux cent quarante mille
huit cent quatre-vingt-dix-sept euros (EUR 34.240.897,-); et

- un montant de trente-quatre millions cent vingt-huit mille quatre-vingt-cinq euros (EUR 34.128.085,-) au Compte de

Prime d'Emission des Parts Sociales Traçantes B au lieu du montant de trente-quatre millions deux cent quarante mille
huit cent quatre-vingt-dix-sept euros (EUR 34.240.897,-)

Toutes les autres dispositions figurant au prédit acte du 20 décembre 2013 demeurent inchangées.

DONT ACTE, fait et passé à Echternach, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire comparant pré-mentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: P. SIMON, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 08 juillet 2014. Relation: ECH/2014/1302. Reçu douze euros 12,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): J.-M. MINY.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 11 juillet 2014.

Référence de publication: 2014103640/74.
(140121892) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2014.

Viva Gestions Immobilières S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 74.603.

Les comptes au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

VIVA GESTIONS IMMOBILIERES S.A.
Jacopo ROSSI / Régis DONATI
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2014103631/12.
(140122384) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2014.

Work Inside Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4220 Esch-sur-Alzette, 20, rue du Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 177.163.

EXTRAIT

En date du 12 juin 2014, la société accepte la cession de parts sociales suivante:
Monsieur Frédéric DESBOIS, gérant de société, né à Le Creusot (F), le 26 janvier 1977, demeurant à F-57070 Metz,

6, rue Liedot

déclare céder DEUX MILLE (2.000) parts sociales qu'il détient à
Madame Kelly MULLER, employée privée, née à Thionville (F), le 5 septembre 1982, demeurant à F-57320 Bouzonville,

9, rue Birck

Suite à cette cession de parts, les parts sociales sont réparties comme suit:

1. - Monsieur Frédéric DESBOIS, prénommé, CINQ MILLE PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.000

2. - Madame Kelly MULLER, prénommée, DEUX MILLE PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000

3. - BKUB S.à r.l., société de droit français, TROIS MILLE PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.000

TOTAL: DIX MILLE PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014103644/20.
(140121773) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2014.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

116496


Document Outline

33 Grosvenor Place Limited

Adel-Fis

Altaira Funds

Andante

Auber S.A.

Bond Relative Return

Caelus Energy International Holdings S.à r.l.

Castle Holding S.A.

China Designer Outlet Mall S.A.

Comfintex S.A.

Cordial Arrow Fund

DA Jupiter Lux LT Holdings S.à r.l.

EuroSwitch Balanced Portfolio OP

EuroSwitch Defensive Concepts OP

FD immobilier

Ferrero International S.A.

Finnovation S.A.

Flaugust S.A.

Generation S.A.

Georgia-Pacific Andes S.à r.l.

Gerana SICAV-SIF, S.A.

GERES Investment S.àr.l.

Ginkgo No. 1

GLL Real Estate Selection Fund

Goldorak Investments

Goodman Alizarin Logistics (Lux) S.à r.l.

Goodman Peppermint Logistics (Lux) S.à r.l.

GPIM Themis

Kirchberg Asset and Investment Management S.à r.l.

LF Real Estate S.à r.l.

Maricath S.A.

Montinvest International S.A.

Next Real Estate Polish Retail Holdco S.à r.l.

Olivetree Absolute Return

One S.à r.l.

PBN Investment S.A.

R.A. Investment Management S.à r.l.

Russian Mortgage Backed Securities 2006-1 S.A.

Styrolution Luxembourg S.à r.l.

Tamata S.à r.l.

The Archstone German Residential Fund II

UniInstitutional European Corporate Bonds +

UniInstitutional European Corporate Bonds +

UniKonzept: Portfolio

UniKonzept: Portfolio

Viva Gestions Immobilières S.A.

White Star S.à r.l.

Work Inside Luxembourg S.à r.l.