logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2133

12 août 2014

SOMMAIRE

20140519 Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

102353

3A Alternative Funds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102345

Adinvest II (Luxembourg) Management

S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102350

Alex Successor SPF S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

102352

Bautra S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102379

C4U2 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102349

Dorin S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102345

Eaton Holding IX S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

102342

EcoSol - Sanem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102347

EDM International  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102343

Fortune Investissement S.A.  . . . . . . . . . . . .

102342

Imaginations S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102384

Inica Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102344

JAB Consumer Fund Management S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102365

Kellogg Lux I S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102339

Kempen Alternative Investment Fund  . . .

102338

Onsen S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102340

Orion Sicav  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102340

Otra Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102340

Patinvest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102339

Petrova-Krivenka société en nom collectif

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102341

Polenergia International S.à r.l. . . . . . . . . . .

102341

Prodiafix-Lux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102338

QSI Finance II (Lux) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

102339

QSI Finance II (Lux) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

102342

Ravago Chemicals S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

102341

R. Coiffure S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102338

Realpromo S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102346

REI SV S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102344

Remae Blanche S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102338

Restaurant-Brasserie Um Dierfgen - Marc

Berg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102341

Retouche Prestige S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

102346

Rhine Acquisitions S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

102344

Rhine (Luxembourg) Holdings S.à r.l.  . . . .

102343

Rorento  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102345

R.P.E. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102346

Rubik Ventures  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102343

Silver Moss B 2014 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

102343

Silver Moss C Mixed 2014 S.à r.l.  . . . . . . . .

102344

Silver Moss C Retail 2014 S.à r.l. . . . . . . . . .

102346

Simple E-Solutions S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

102345

Stabilus S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102375

Tilad Bavaria Investment Company Limi-

ted  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102364

Ukrainian Agrarian Investments S.A.  . . . .

102384

102337

L

U X E M B O U R G

Remae Blanche S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 2A, rue des Capucins.

R.C.S. Luxembourg B 88.852.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014079468/9.
(140093778) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2014.

R. Coiffure S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 54, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 174.535.

Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014079457/10.
(140093461) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2014.

Prodiafix-Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4276 Esch-sur-Alzette, 58, rue Louis Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 138.789.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 23 mai 2014.

Pour statuts coordonnés

Référence de publication: 2014079450/11.
(140093879) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2014.

Kempen Alternative Investment Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6C, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 82.955.

<i>Extrait des Décisions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 15 mai 2014

Composition du Conseil d'administration:
- Il a été décidé de réélire Messieurs Henry Kelly, Hendrik Luttenberg, Jacques Elvinger ainsi que Monsieur Patrick

Hermse en tant qu'Administrateurs de la Société jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur
l'année comptable se terminant le 31 décembre 2014.

- Il a été décidé de renouveler le mandat de Deloitte S.A., en tant que réviseur d'entreprises jusqu'à la prochaine

Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur l'année comptable se terminant le 31 décembre 2014.

Au 15 mai 2014, le Conseil d'Administration se compose comme suit:
- Mr. Henry Kelly (Président)
- Mr. Hendrik Luttenberg
- Mr. Jacques Elvinger
- Mr. Patrick Hermse
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 06 juin 2014.

KEMPEN ALTERNATIVE INVESTMENT FUND
Au nom et pour le compte de J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A
<i>Agent domiciliataire

Référence de publication: 2014080861/24.
(140095226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2014.

102338

L

U X E M B O U R G

QSI Finance II (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 164.283.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juin 2014.

QSI Finance II (Lux) S.à r.l.
TMF Corporate Services S.A. / D. A. Jensen
<i>Gérant A / Gérant B

Référence de publication: 2014079455/13.
(140093572) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2014.

Patinvest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 5, rue Alphonse Weicker.

R.C.S. Luxembourg B 21.360.

Référence est faite à l'extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration en date du 19 mars 2014 déposé

le  01  avril  2014  sous  la  référence  L140053419  et  publié  le  30  mai  2014  au  Mémorial  C  n°  1390  sous  la  référence
2014046712/16.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale statutaire tenue exceptionnellement le 17 avril 2014

- la cooptation de Monsieur Jean CHAUSSE en tant qu'Administrateur de catégorie A, est ratifiée. Son mandat viendra

à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2015.

Fait à Luxembourg, le 10 juin 2014.

Certifié sincère et conforme

Référence de publication: 2014081064/15.
(140095858) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2014.

Kellogg Lux I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 103.831.

L'an deux mille quatorze, le dix juin,
L'associé unique décide en date du 27 mars 2014 la nomination aux fonctions de gérant avec effet immédiat de:
- Peter James Headridge, gérant, né le 8 juillet 1971 à Sheffield (UK) demeurant à SK12 1JG Stockport Cheshire (UK),

15 Queensway Poynton;

- Christopher Hood, gérant, né le 5 avril 1962 à Minnesota (USA) demeurant à 1296 Coppet (CH), 20 Ch. Des Pessules.
L'associé unique décide en date du 27 mars 2014 la révocation imédiate aux fonctions de gérant avec effet immédiat

de:

- Paul Timothy Norman, gérant, né le 12 novembre 1964 à Southampton (UK), demeurant à 49024 Michigan (USA),

6611 Oleander Lane;

- Joel Vanderkooi, gérant, né le 24 septembre 1968 à Michigan (USA), demeurant à 49009 Kalamazoo (USA), 8384

Morning Dove Lane.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DIEKIRCH, le 10 juin 2014.

<i>Pour la société
COFICOM Trust S.à r.l.
B.P. 126
50, Esplanade
L-9227 DIEKIRCH
Signature

Référence de publication: 2014080847/26.
(140095478) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2014.

102339

L

U X E M B O U R G

Onsen S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 141.927.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait sincère et conforme
ONSEN S.A.

Référence de publication: 2014081031/11.
(140095259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2014.

Orion Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 73.862.

<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 22 avril 2014

L'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
1. de réélire Mesdames Evelyne Cadillon et Barbara Nicolas ainsi que Messieurs Jean-Michel Gelhay et Régis Léoni, en

qualité d'administrateurs, pour le terme d'un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2015,

2. de réélire KPMG Luxembourg S.à.r.l., en qualité de Réviseur d'Entreprises pour le terme d'un an, prenant fin à la

prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2015.

Luxembourg, le 10 juin 2014.

<i>Pour ORION SICAV
BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent Domiciliataire

Référence de publication: 2014081039/17.
(140095887) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2014.

Otra Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 5.610.000,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 75.538.

L'adresse de l'associé unique suivant a changé comme suit:
Monsieur Jan-Rolf Renatus Behlau, demeurant au 22, Avenue Emile Duray, BE-1050 Bruxelles, Belgique.
Suite à la donation de parts en date du 30 avril 2014 entre Monsieur Jean-Rolf Renatus Behlau et Madame Lucia Zünkler-

Behlau, née le 24 mai 1969 à Korschenbroich, Allemagne, demeurant au 22, Avenue Emile Duray, BE-1050 Bruxelles,
Belgique, l'usufruit de 2.929 parts sociales d'une valeur nominale de EUR 1.000 chacune est transféré à Madame Lucia
Zünkler-Behlau.

Suite à la donation de parts en date du 30 avril 2014 entre Monsieur Jean-Rolf Renatus Behlau et Messieurs:
- Christopher J.N. Behlau, né le 6 décembre 1981 à Zürich, Suisse, demeurant au 141 Atlantic Avenue, Brooklyn, NY

11201, Etats-Unis d'Amérique;

- Julien E.P. Behlau né le 23 novembre 1980 à Zürich, Suisse, demeurant au 1307 Danielson Road, Santa Barbara, CA

93108, Etats-Unis d'Amérique;

- Stefan C.A. Behlau né le 26 juillet 1979 à Zürich, Suisse, demeurant au 22, Avenue Emile Duray, BE-1050 Bruxelles,

Belgique,

la nue-propriété de 2.929 parts sociales d'une valeur nominale de EUR 1.000 chacune est transférée à Messieurs

Christoph J.N. Behlau, Julien E.P. Behlau, Stefan C.A. Behlau en indivision.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Otra S.à r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
<i>Gérant

Référence de publication: 2014081041/26.
(140095787) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2014.

102340

L

U X E M B O U R G

Restaurant-Brasserie Um Dierfgen - Marc Berg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 4-6, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 71.261.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014079470/9.
(140093915) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2014.

Ravago Chemicals S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 16, rue Notre-Dame.

R.C.S. Luxembourg B 91.789.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 68665 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014079459/10.
(140093538) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2014.

Petrova-Krivenka société en nom collectif, Société en nom collectif.

R.C.S. Luxembourg B 107.642.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait

Par jugement rendu en date du 22 mai 2014, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,

siégeant en matière commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Mi-
nistère Public en leurs conclusions, déclare closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société en nom
collectif PETROVA-KRIVENKA société en nom collectif, en enseigne PF. BROKER SENC, dont le siège social à L-2163
Luxembourg, 29, avenue Monterey, a été dénoncé en date du 28 avril 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
Pierre-Yves MAGEROTTE
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2014081049/17.
(140095175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2014.

Polenergia International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 137.779.

<i>Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 21 mars 2014

1. Mme Zuzanna ZIELINSKA-ROUSSEAU a démissionné de son mandat de gérante, avec effet au 28 février 2014.
2. M. Jean-Christophe DAUPHIN, administrateur de sociétés, né à Nancy (France), le 20 novembre 1976, demeurant

professionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommé comme gérant de classe B, avec effet
au 21 mars 2014, pour une durée indéterminée.

Veuillez noter que l'adresse professionnelle de Monsieur Gérard BIRCHEN, gérant de classe B, se situe désormais au

L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert avec effet au 21 mars 2014.

Luxembourg, le 10 juin 2014.

Pour extrait et avis sincères et conformes
<i>Pour Polenergia International S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2014081050/18.
(140095345) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2014.

102341

L

U X E M B O U R G

QSI Finance II (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 164.283.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juin 2014.

QSI Finance II (Lux) S.à r.l.
TMF Corporate Services S.A. / D. A. Jensen
<i>Gérant A / Gérant B

Référence de publication: 2014079456/13.
(140093601) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2014.

Fortune Investissement S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 73.283.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue en date du 2 juin 2014:

«L'assemblée prend acte de la démission de M. Giovanni VITTORE des fonctions de président du Conseil d'Adminis-

tration et d'administrateur. L'Assemblée décide de nommer aux fonctions d'Administrateur et de Président du Conseil
d'Administration, Monsieur Jeannot DIDERRICH, expert-comptable, demeurant professionnellement au 45-47, route
d'Arlon, L-1140 Luxembourg, qui terminera le mandat de son prédécesseur jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra
en 2015».

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FORTUNE INVESTISSEMENT S.A.

Référence de publication: 2014080717/15.
(140095195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2014.

Eaton Holding IX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 137.021.

Il est a noté que suivant un contrat de cession de parts sociales en date du 4 juin 2014 l'associé unique de la Société

Eaton Industries (Luxembourg) B.V / S.à r.l, une société régie par le droit néerlandais, ayant son siège social sis au Euro-
palaan 202, 7559 SC Hengelo Ov, Pays-Bas et son lieu effectif d'activité sis au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés d'Amsterdam sous le
numéro 33296220, a transféré les 500 (cinq cents) parts sociales d'une valeur nominale de 25 EUR (vingt-cinq Euro)
chacune, qu'elle détenait dans la Société à Cooper Offshore Holdings S.à r.l., société à responsabilité limitée régie par les
lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social sis au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 183.444.

L'actionnariat de la Société est désormais composé comme suit:
Associé: Cooper Offshore Holdings S.à r.l.
Parts sociales détenues dans la Société: 500 (cinq cents) parts sociales d'une valeur nominale de 25 EUR (vingt-cinq

Euro) chacune.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 juin 2014.

<i>Pour la Société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014080363/26.
(140094360) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juin 2014.

102342

L

U X E M B O U R G

Rubik Ventures, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 101.600,00.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 119.544.

Les comptes annuels au 30 avril 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014079465/9.
(140093964) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2014.

Rhine (Luxembourg) Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 60.000,00.

Siège social: L-2328 Luxembourg, 20, rue des Peupliers.

R.C.S. Luxembourg B 182.426.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 juin 2014.

Référence de publication: 2014079461/10.
(140093894) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2014.

Silver Moss B 2014 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: CHF 64.000,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 13, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 186.797.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 05 juin 2014.

Référence de publication: 2014079487/11.
(140093367) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2014.

EDM International, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 50.523.

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui s'est tenue en date du 27 mai 2014:
1. A renouvelé le mandat de Messieurs:
- Juan DIAZ MORERA
Travessera de Gracia, 29, 4, 08021 Barcelone, Espagne
- Lluis FORTUNY
Avenue Diagonal, 399, 3, 08008 Barcelone, Espagne
- Antonio ESTABANELL BUXÖ
Avenue Diagonal, 399, 3, 08008 Barcelone, Espagne
à la fonction d'administrateurs de la société pour une période d'un an se terminant à l'assemblée générale ordinaire

de 2015.

2. A renouvelé le mandat de réviseur d'Entreprises de Deloitte Audit S.à r.l., 560, route de Neudorf, L-2220 Luxem-

bourg, pour une période d'un an se terminant à l'assemblée générale ordinaire de 2015.

Esch-sur-Alzette, le 11 Juin 2014.

<i>Pour EDM INTERNATIONAL
SICAV
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.
Société Anonyme

Référence de publication: 2014081526/24.
(140096572) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2014.

102343

L

U X E M B O U R G

REI SV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 180.255.

Les comptes Annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juin 2014.

Référence de publication: 2014079467/10.
(140092944) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2014.

Rhine Acquisitions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 55.000,00.

Siège social: L-2328 Luxembourg, 20, rue des Peupliers.

R.C.S. Luxembourg B 182.509.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 juin 2014.

Référence de publication: 2014079462/10.
(140093895) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2014.

Silver Moss C Mixed 2014 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: CHF 16.000,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 13, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 186.808.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 05 juin 2014.

Référence de publication: 2014079488/11.
(140093343) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2014.

Inica Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, Avenue J.F Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 187.494.

En date du 03 juin 2014 l'associé unique de la Société a pris les décisions suivantes:
1. L'acceptation de la démission de Manacor (Luxembourg) S.A de ses fonctions de gérante unique de la Société avec

effet au 02 juin 2014;

2. Election des nouveaux gérantes de catégorie A, à compter du 02 juin 2014 pour une durée indéterminée:
- Monsieur Robert Strietzel, né le 10 septembre 1975, à Schwerin, Allemagne, ayant pour adresse professionnelle 46A,

Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg;

- Monsieur Jorge Pérez Lozano, né le 17 août 1973, à Mannheim, Allemagne, ayant pour adresse professionnelle 46A,

Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg.

3. Election d'un nouveau gérant de catégorie B, à compter du 02 juin 2014 pour une durée indéterminée:
- Madame Carolina von Groddeck, née le 19 Avril 1969, à Hamburg, Allemagne, ayant pour adresse professionnelle

Rotfeder-Ring 7, D-60327 Frankfurt am Main, Allemagne.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Inica Holding S.àr.l.
Robert Strietzel
<i>Gérant A

Référence de publication: 2014080790/23.
(140095828) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2014.

102344

L

U X E M B O U R G

Dorin S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 156.365.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014079480/9.
(140094163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2014.

Simple E-Solutions S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 86.599.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014079545/9.
(140093923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2014.

Rorento, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 177.719.

Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour RORENTO
Société d'Investissement à Capital Variable
RBC Investor Services Bank S.A.
Société Anonyme

Référence de publication: 2014079479/13.
(140093236) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2014.

3A Alternative Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1160 Luxembourg, 16, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 88.843.

EXTRAIT

L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue au siège social le 19 mai 2014 a adopté les résolutions sui-

vantes:

1. L'assemblée a élu comme Administrateur jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2015:
- Monsieur Régis Deymié (demeurant au Luxembourg, 74 Grand Rue 1660 Luxembourg),
- Monsieur Massimo Paolo Gentili (demeurant au Luxembourg, 11 rue Beatrix de Bourbon, 1225 Luxembourg),
- Monsieur Xavier Guillon (demeurant en Suisse, Rue du Rhône 30,1204 Genève),
- Monsieur Jérôme Wigny (demeurant au Luxembourg, 2 Place Winston Churchill, 2014 Luxembourg)
2. L'Assemblée a ré-élu comme Administrateurs jusqu'à la prochaine assemblée ordinaire qui se tiendra en 2015:
- Monsieur Jean Keller (demeurant en Suisse, 12 route de Malagny, 1294 Genthod),
2. L'assemblée a ré-élu PricewaterhouseCoopers Société coopérative, dont le siège social se situe 400 route d'Esch

L-1471 Luxembourg, à la fonction de Réviseur d'Entreprises pour une période d'un an se terminant à l'Assemblée Générale
Ordinaire de 2015.

<i>Pour 3A ALTERNATIVE FUNDS
HSBC Securities Services (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2014081307/23.
(140095612) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2014.

102345

L

U X E M B O U R G

Retouche Prestige S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7240 Bereldange, 1A, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 117.188.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014079471/9.
(140093854) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2014.

Realpromo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 10, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 63.718.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014079466/10.
(140093354) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2014.

Silver Moss C Retail 2014 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: CHF 16.000,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 13, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 186.830.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 05 juin 2014.

Référence de publication: 2014079489/11.
(140093352) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2014.

R.P.E. S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 41.652.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 28 avril 2014:

L'Assemblée appelle aux fonctions d'administrateur Monsieur Claudio TOMASSINI, 40, Boulevard Joseph II, L-1840,

Luxembourg et Monsieur Henri REITER, 40, Boulevard Joseph II, L-1840, Luxembourg en remplacement de Monsieur
Marco NEUEN, 40, Boulevard Joseph II, L-1840, Luxembourg et Monsieur René SCHLIM, 40, Boulevard Joseph II, L-1840,
Luxembourg. Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 dé-
cembre 2018.

Après en avoir délibéré, l'Assemblée Générale renomme:
- Monsieur Jacques RECKINGER, avec adresse professionnelle au 40, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux

fonctions d'administrateur;

Leurs mandats respectifs prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 dé-

cembre 2018.

L'Assemblée Générale renomme comme commissaire aux comptes:
- FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG, société anonyme, 38, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2018.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg

Référence de publication: 2014081087/24.
(140095206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2014.

102346

L

U X E M B O U R G

EcoSol - Sanem, Association sans but lucratif.

Siège social: L-4477 Belvaux, 60, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg F 9.990.

STATUTS

Entre les soussignés, membres fondateurs:
Asselborn-Bintz Simone
Cecchetti Myriam
Cozzi Tamara
De Rocco Magali
Goerend Nathalie
Morgenthaler Nathalie
Olmo Serge
Phillips Catherine
Piscitelli Jos
Rod Gilles
Sander Beate
Speck-Braun Patricia
Steffen Josy
est crée par la présente une association sans but lucratif, régie par les dispositions de la loi du 21 avril 1928 telle qu'elle

a été modifiée et les présents statuts.

Art. 1 

er

 . Dénomination, siège et durée.  L'association prend la dénomination «EcoSol - Sanem» a.s.b.l. (Economie

Solidaire et sociale - Commune de Sanem)

Son siège est établi dans la Commune de Sanem.
Le siège pourra être transféré à l'intérieur du territoire de la Commune de Sanem par simple décision du Conseil

d'administration et dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'Assemblée gé-
nérale statuant en matière de modification des statuts.

L'association est créée pour une durée illimitée.

Art. 2. Objet. L'association a pour objet de réaliser, promouvoir, développer et soutenir la promotion d'une économie

sociale et solidaire qui se base essentiellement sur un développement de synergies entre les différents acteurs socio-
économiques sur le plan local et régional dans une approche sociale, écologique et économique.

Les axes principaux de son action concernent la lutte contre l'exclusion sociale par la création et le maintien d'emplois

ainsi que le développement de nouveaux secteurs d'activité sur le plan local et régional qui pourra prendre les formes
suivantes (énumération non prioritaire et non exhaustive):

- mise en place et opération d'une épicerie solidaire,
- organisation d'une guidance socio-éducative vers des aides et prises en charge sociales,
- favorisation d'une approche communautaire et participative,
- soutenir des partenariats avec des organismes actifs dans la promotion d'activités sociales, écologiques et économi-

ques

- formations théoriques et/ou pratiques, stages (au sens large).
L'association se réserve le droit d'administrer et de gérer, y compris d'acquérir, de louer et de vendre tous biens

meubles et immeubles nécessaires à ces fins. Elle pourra également organiser des activités culturelles à destination et/ou
au profit de son public-cible.

Pour réaliser ces actions, l'association procédera à la recherche de subventionnement public et de sponsoring privé

et aux signatures de contrats et conventions ad hoc.

L'association poursuit son activité dans une stricte indépendance politique, idéologique et religieuse mais n'excluant

aucun partenariat tant avec les pouvoirs publics qu'avec des organismes privés du secteur de l'économie sociale et solidaire
comme du secteur économique non protégé.

De manière générale, l'association engage sa responsabilité sociale par le respect des standards de bonne gouvernance

démocratique et s'emploie à former à des activités favorisant un développement sociétal sur plan local et régional.

Art. 3. Membres. L'association se compose de membres associés qui sont nommés «membres actifs» et de membres

donateurs auxquels elle délivre des cartes de membres différentes.

Le paiement de la cotisation donne droit à une carte de membre démontrant l'affiliation à l'association pour une année

de calendrier. Le montant de la cotisation est fixé annuellement par l'Assemblée générale et ne peut dépasser 100 euros.

102347

L

U X E M B O U R G

3.1 Les membres actifs
Peut devenir membre actif toute personne physique ou morale qui désire participer aux activités de l'association et

qui justifie des liens avec l'association, qui s'est particulièrement distinguée dans le domaine de la lutte contre l'exclusion
sociale du pays et qui paie chaque année la cotisation annuelle.

Pour devenir membre actif, le candidat doit adresser une demande motivée au Conseil d'administration laquelle devra

être appuyée par deux membres actifs. L'admission d'un membre actif est formalisée par une décision du Conseil d'ad-
ministration statuant à la majorité des voix et, en cas de demande, au scrutin secret.

En cas de refus par le Conseil d'administration, un recours est possible devant la prochaine Assemblée générale.
Seuls les membres actifs ont le droit de vote à l'Assemblée générale.
Seuls les membres actifs peuvent être élus au Conseil d'administration.
Les membres du personnel de l'association ne sont pas éligibles en tant que membres actifs.
3.2 Les membres donateurs
Peut devenir membre donateur toute personne physique ou morale désirant apporter un soutien financier à l'asso-

ciation en payant chaque année la cotisation annuelle. Le paiement de la cotisation donne uniquement droit à une carte
de membre démontrant l'affiliation à l'association pour une année de calendrier. La carte de membre donateur ne confère
aucun droit de propriété au niveau de l'association ni droit de vote à l'assemblée générale.

Le non-paiement de la cotisation annuelle met fin à l'affiliation à l'association de la personne physique ou morale

concernée pour l'année en question.

Art. 4. Démission ou exclusion de membres actifs. Tout membre actif est libre de se retirer de l'association à tout

moment en adressant sa démission écrite au Conseil d'administration.

Est  démissionnaire  de  plein  droit  tout  membre  actif  qui  n'a  pas  acquitté  sa  cotisation  annuelle  avant  la  tenue  de

l'Assemblée générale.

Le Conseil d'administration peut prononcer l'exclusion d'un membre actif qui d'une manière quelconque porte atteinte

aux intérêts et/ou à la finalité sociale ou aux objets de l'association.

La mesure d'exclusion ne pourra être appliquée sans que l'intéressé ait été informé de la mesure envisagée à son

encontre et des motifs la justifiant et, s'il en exprime le souhait, ait eu l'occasion de fournir des explications.

Les membres associés démissionnaires ou exclus ne peuvent porter atteinte à l'existence de l'association et n'ont

aucun droit à faire valoir ni sur son patrimoine ni sur les cotisations payées.

Art. 5. L'Assemblée générale. L'Assemblée générale se compose de tous les membres actifs et se réunit ordinairement

chaque année avant la fin du mois de juin sur convocation du Conseil d'administration par lettre ordinaire au moins huit
(8) jours avant la date de la réunion de l'Assemblée. La convocation doit indiquer l'ordre du jour proposé.

Une Assemblée générale extraordinaire sera convoquée chaque fois que les intérêts de l'association l'exigent ou qu'un

cinquième des membres actifs le demande par écrit au Conseil d'administration.

L'Assemblée générale prend ses décisions à la simple majorité des membres actifs présents ou représentés. Chaque

membre actif dispose d'un vote et peut se faire représenter par procuration écrite à l'Assemblée générale par un autre
membre actif.

L'Assemblée générale est présidée par le Président du Conseil d'administration, ou par un membre dûment mandaté

à cet effet.

L'Assemblée générale ne peut valablement délibérer sur une modification des statuts que si l'objet de la modification

est spécialement indiqué dans la convocation et si l'Assemblée réunit les deux tiers des membres actifs. Une telle modi-
fication peut seulement être adoptée à la majorité des deux tiers des voix.

Si le quorum nécessaire de deux tiers des membres associés n'est pas atteint lors d'une première assemblée, une

seconde Assemblée générale peut être convoquée qui pourra délibérer quel que soit le nombre des membres actifs
présents; mais, dans ce cas la décision sera soumise à l'homologation du tribunal civil.

Toutefois, si la modification porte sur l'un des objets en vue desquels l'association s'est constituée, soit sur sa disso-

lution, les règles suivantes s'appliquent:

- La seconde assemblée ne sera valablement constituée que si la moitié au moins de ses membres actifs est présente

ou représentée,

- la décision n'est admise dans l'une ou dans l'autre assemblée, que si elle est adoptée à la majorité des trois quarts

des voix des membres actifs présents ou représentés,

- si, dans la seconde assemblée les deux tiers des membres actifs ne sont pas présents ou représentés, la décision

devra être que par le tribunal civil.

Sont de la compétence exclusive de l'Assemblée générale:
- Les modifications des statuts;
- La nomination et la révocation des administrateurs et réviseurs de caisse;
- L'approbation des budgets et des comptes;

102348

L

U X E M B O U R G

- La dissolution volontaire de l'association.
Les décisions et résolutions de l'Assemblée générale sont inscrites dans un registre spécial qui est tenu au siège de

l'association. Tous les membres et les tiers peuvent consulter ce registre sur demande.

Art. 6. Le Conseil d'administration. L'association est gérée par un Conseil d'administration qui est élu à la majorité

simple des membres actifs présents ou représentés à l'Assemblée générale.

Le Conseil d'administration se compose de 5 membres au minimum et 13 membres au maximum.
Les administrateurs sont élus pour une durée de 2 ans par l'assemblée générale et désigneront parmi eux les mandats

respectifs du Président, de deux Vice-présidents, du Secrétaire et du Trésorier.

Les mandats des administrateurs sont révocables. Toutes les fonctions exercées dans les organes de l'association ont

un caractère bénévole et les administrateurs renoncent à toute rémunération.

Les administrateurs sortants sont rééligibles.
L'association sera valablement engagée par la signature conjointe du Président - ou à défaut d'un Vice-président - et

d'un membre du Conseil d'administration dûment mandaté à cet effet.

Le Conseil d'administration gère les affaires de l'association et la représente dans tous les actes judiciaires et extra-

judiciaires.

Le  Conseil  d'administration  se  réunit  au  moins  trois  fois  par  an  sur  l'initiative  du  Président  ou  du  Secrétaire  qui

proposent l'ordre du jour. Le Conseil d'administration ne peut statuer que si la majorité de ses membres sont présents
ou représentés. Aucun administrateur ne peut porter plus d'une procuration à une réunion du conseil d'administration.

Le Conseil d'administration prend ses décisions à la majorité absolue. En cas de partage des voix, celle du Président

ou de son remplaçant est prépondérante.

Les décisions du Conseil d'administration sont notées sous forme de procès-verbaux et sont inscrites dans un registre

spécial.

Art. 7. Comptes annuels et commissaire aux comptes. La vérification de l'état des recettes et des dépenses de l'as-

sociation devra être faite par au moins un commissaire aux comptes élu à cet effet par l'Assemblée générale, pour une
durée de 2 ans. Le(s) commissaire(s) sortants sont rééligibles.

Le Conseil d'administration soumet annuellement à l'Assemblée générale les comptes annuels de l'exercice écoulé,

ainsi qu'un budget prévisionnel sur l'exercice à venir. L'Assemblée générale votera sur l'approbation des comptes, sur la
décharge à donner aux administrateurs après avoir entendu les rapports du Conseil d'administration et du/des commis-
saire(s) aux comptes et/ou d'un réviseur d'entreprise compétent, étranger à l'association nommé à cet effet.

Art. 8. Exercice social. L'exercice social commence le 1 

er

 janvier et prend fin le 31 décembre.

Art. 9. Dissolution. En cas de dissolution de l'association, l'actif net est affecté à une autre association sans but lucratif

reconnue d'utilité publique ou à une fondation poursuivant une activité analogue.

Art. 10. Dispositions générales. Le Conseil d'administration complète les listes des membres chaque année par l'indi-

cation des modifications qui se sont produites et ce endéans un mois à partir de la clôture de l'année sociale.

Pour toutes matières non-réglées par les présents statuts, il est fait référence à la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les

associations et les fondations sans but lucratif.

Référence de publication: 2014081513/149.
(140095306) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2014.

C4U2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 25, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 111.875.

EXTRAIT

Par la présente, je vous informe de ma démission en tant qu'Administrateur de la société de droit luxembourgeois

C4U2 S.A., enregistrée au registre de commerce du Grand-Duché de Luxembourg, sous le numéro B111875.

Luxembourg, le 07 février 2014.

Jean-Pierre DE WOLF
<i>Administrateur

Référence de publication: 2014081488/13.
(140096028) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2014.

102349

L

U X E M B O U R G

Adinvest II (Luxembourg) Management S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 133.982.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-sixth day of the month of May.
Before Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

ADINVEST HOLDING AG, a company incorporated under the laws of Switzerland, with registered office at Rigistrasse

25, 8126 Zumikon, Switzerland and registration number CH-020.3.900.261-0;

in its capacity as sole shareholder of ADINVEST II (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.à r.l. (the "Company"), a

société à responsabilité limitée, having its registered office at 412F, Route d'Esch, L-2086 Luxembourg, registered with
the Registre de Commerce et des Sociétés of Luxembourg under number B 133.982, having a share capital of EUR 12,500,
incorporated on 21 November, 2007 by deed of Maître Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg, published in
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 3003 of 27 December 2007. The articles of association of the
Company (the Articles) have been amended by deed of Maître Joseph ELVINGER, prenamed, on 21 January 2008, pu-
blished in Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 821 of 4 April 2008;

here represented by Sabine JULI, employee, with professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

by virtue of a proxy given under private seal on 20 May 2014.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned

notary, shall remain attached to this notarial deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary, to enact the following:
I. ADINVEST HOLDING AG is the sole shareholder of the Company (the Sole Shareholder) and represents the entire

share capital of the Company;

II. the Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) represented by five hundred

(500) shares, with a par value of one hundred euro (EUR 25) per share;

III. the Sole Shareholder takes the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting resolved unanimously to amend article 11 of the Company's articles of association to read as follows:
“The Company is managed by several managers, which do not need to be partners. In dealings with third parties, the

managers have the most extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all
transactions consistent with the Company's purpose. The managers are appointed by the general meeting of partners
which sets the term of their office. They may only be dismissed for cause.

The partners may decide to appoint one or more managers of each of category A and category B. The Company shall

be bound towards third parties in all matters by the sole signature of any manager of category A, the joint signatures of
any manager of category A and any manager of category B of the Company or by the joint or single signatures of any
persons to whom such signatory power has been validly delegated by the board of managers.

In case of an equally split vote of the managers concerning a decision to be taken, such proposed decision shall be

referred to the investment committee of the Company for review and consultation with the managers. In the event that
there is no agreement reached between the managers at the end of this consultation process, the issue shall be deferred
to the extraordinary general meeting of shareholders of ADINVEST II (LUXEMBOURG) S.C.S., SICAR if the issue at
stake concerns the affairs of the SICAR, or to the general meeting of shareholders of the Company if the issue at stake
only concerns the affairs of the Company. The decision of the general meeting of shareholders so convened shall be
binding on the managers, who shall make all necessary arrangements to implement this decision without delay. The use
of video-conferencing equipment and conference call shall 3 be allowed provided that each participating member of the
board of managers is able to hear and to be identified and heard by all other participating members whether or not using
this technology, and each participating member of the board of managers shall be deemed to be present and shall be
authorised to vote by video or by telephone.

The board of managers may, unanimously, pass circular resolutions on one or several similar documents in writing or,

subject to submitting a written confirmation thereafter, by e-mail, by fax transmission or by any similar means of com-
munication. These resolutions shall have the same effect as resolutions voted at the physically held board of managers'
meetings. Votes may also be cast by e-mail, fax transmission or by telephone provided that such vote is confirmed in
writing”.

<i>Second resolution

The meeting unanimously decided to appoint Dr. Neil SUNDERLAND, Manager, born on 10 July 1945, in the United

Kingdom, residing at Rigistrasse 25, CH-8126 Zumikon as category A manager of the Company.

102350

L

U X E M B O U R G

<i>Third resolution

The meeting unanimously decided to appoint Mr. Oliver JUNG, Manager, born on 5 July 1972 in Germany, residing

Bachtelstrasse 18 CH-8808 Pfäffikon as category B manager of the Company.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately one thousand Euros (EUR 1,000.-).

<i>Statement

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same appearing party
and in case of divergences between the English and the French versions, the English version will prevail.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this do-

cument.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the undersigned notary by her

surname, name, civil status and residence, the said proxyholder signed the present original deed together with the un-
dersigned notary.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le vingt-six mai,
Par-devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

A COMPARU

ADINVEST HOLDING AG, une société constituée d'après les lois suisses, ayant son siège social à Rigistrasse 25, 8126

Zumikon, Suisse, avec numéro d'immatriculation CH-020.3.900.261-0

en sa qualité d'associé unique de ADINVEST II (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.à r.l, ayant son siège social à 412F,

route d'Esch, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés Luxembourgeois sous le numéro B.133.982, ayant
un capital social de EUR 12.500, constituée suivant acte reçu le 29 novembre 2007 par un acte de Maître Joseph ELVINGER,
notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 3003 du 27
décembre 2007. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Joseph ELVINGER,
prénommé, le 21 janvier 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 821 du 4 avril 2008,

ici représentée par Sabine JULI, employée privée, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, Grand-Duché de

Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 20 mai 2014.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instru-

mentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Adinvest Holding AG est l'associé unique de la Société (l'Associé Unique) et représente l'intégralité du capital social

de la Société;

II. Le capital social de la Société est de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) représenté par cinq cents (500)

parts sociales, ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 25) chacune;

III. L'Associé Unique prend les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée a décidé à l'unanimité de modifier l'article 11 des Statuts concernant l'administration de la société afin

qu'il soit lu comme suit:

“La Société est gérée par plusieurs gérants, qui ne doivent pas nécessairement être associés. Dans les rapports avec

les tiers, les gérants ont les pouvoirs les plus larges pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour
autoriser toutes opérations compatibles avec l'objet de la Société. Les gérants sont nommés par l'assemblée générale des
associés, qui fixe les conditions de leur mandat. Ils ne peuvent être révoqués que pour un juste motif.

Les associés peuvent décider de nommer un ou plusieurs gérants de chaque catégorie A et catégorie B. La Société

sera liée envers les tiers dans toutes les matières par la signature unique de tout gérant de catégorie A, les signatures
conjointes de tout gérant de catégorie A et tout gérant de catégorie B de la Société ou par la signature conjointe ou
unique de personnes à laquelle un tel pouvoir de signature a été valablement délégué par le conseil de gérance.

En cas de désaccord entre les gérants concernant une décision sur le point d'être prise, celle-ci sera alors transmise

au comité d'investissement de la Société, pour revue et consultation avec les gérants. Au cas où aucun accord n'aura été
trouvé entre les gérants au terme de la procédure de consultation, le point de désaccord sera porté devant l'assemblée
générale extraordinaire des actionnaires d'ADINVEST II (LUXEMBOURG) S.C.S., SICAR si le point en question concerne
les affaires de la SICAR, où à l'assemblée générale des actionnaires de la Société si le point en question concerne les

102351

L

U X E M B O U R G

affaires de la Société. La décision de l'assemblée générale appropriée sera contraignante pour les gérants qui devront faire
le nécessaire pour appliquer cette décision sans délai.

L'utilisation de la visioconférence et de conférence téléphonique est autorisée si chaque participant est en mesure

d'entendre et d'être identifié et entendu par tous les membres du conseil de gérance participants à la réunion en utilisant
ou non ce type de technologie et chaque participant sera réputé présent à la réunion et sera habilité à prendre part au
vote via ce type de technologie.

Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, prendre des résolutions circulaires sur un ou plusieurs documents similaires

par écrit ou, avec confirmation postérieur par écrit, par e-mail, fax ou tout autre moyen de communication similaire. Ces
résolutions auront le même effet que des résolutions votées lors d'une réunion du conseil de gérance physiquement 6
tenue. Des votes pourront également être exprimés par e-mail, fax ou téléphone, et dans cette hypothèse, le vote devra
être confirmé par écrit.”

<i>Deuxième résolution

L'assemblée a décidé à l'unanimité de nommer Dr. Neil SUNDERLAND, gérant, né le 10 juillet 1945, au Royaume-

Uni, demeurant à Rigistrasse 25, CH-8126 Zumikon comme gérant de catégorie A de la Société.

<i>Troisième résolution

L'assemblée a décidé à l'unanimité de nommer Monsieur Oliver JUNG, gérant, né le 5 juillet 1972, en Allemagne,

demeurant à Bachtelstrasse 18, CH-8808 Pfäffikon comme gérant de catégorie B de la Société.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, sont estimés approximativement à la somme de mille euros (EUR
1.000,-).

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte

a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante et en cas de divergence
entre les versions anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, fait et passé, même date qu'en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture faite à la mandataire de la personne comparante, connue du notaire soussigné par son nom, prénom

usuel, état civil et demeure, ladite mandataire de la personne comparante a signé avec le notaire soussigné le présent
acte.

Signé: S. JULI, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 28 mai 2014. LAC/2014/24735. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 6 juin 2014.

Référence de publication: 2014082048/146.
(140097022) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2014.

Alex Successor SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 163.258.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l'actionnaire unique prises en date du 6 juin 2014 que:
1. Monsieur Andrey KOSYRIKHIN a été révoqué de son poste d'administrateur de la Société avec effet immédiat.
2. Madame Anastasia MARTYNOVA, née le 25 mars 1972 à Moscou, Russie, résidant au 22, Chongarskiy boulevard,

building 2, apt 71, 117149 Moscou, Russie a été nommée administrateur de la Société avec effet immédiat et ce, pour une
durée de 6 années.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme

Luxembourg, le 11 juin 2014.

Référence de publication: 2014082021/16.
(140097171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2014.

102352

L

U X E M B O U R G

20140519 Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8036 Strassen, 19, rue des Lilas.

R.C.S. Luxembourg B 187.658.

STATUTES

In the year two thousand and fourteen, on the thirtieth day of May,
Before us Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

THERE APPEARED:

Emerging Markets Online Food Delivery Holding S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing

under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register
under number B 175738, having its registered address at 7, avenue J.P. Pescatore, L - 2324 Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg,

here represented by Ms Alix van der Wielen, maître en droit, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a

proxy, given in Berlin, Germany and in Luxembourg.

Said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to

this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such  appearing  party  has  requested  the  officiating  notary  to  enact  the  deed  of  incorporation  of  a  private  limited

company (société à responsabilité limitée) which it wishes to incorporate with the following articles of association:

A. Name - Purpose - Duration - Registered office

Art. 1. Name - Legal Form. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name

20140519 Holding S.à r.l. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning
commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.

Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign

companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio in view of its realisation by sale, exchange or otherwise.

2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it

holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the
Company.

2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by

issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.

2.4 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities

which it considers useful for the accomplishment of these purposes.

Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of

managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution
of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution

of the board of managers.

4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances

or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
traordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwiths-
tanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

B. Share capital - Shares

Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), represented by:

102353

L

U X E M B O U R G

5.1.1 one thousand two hundred fifty (1,250) common shares, with a nominal value of one euro (EUR 1) each (the

“Common Shares”); and

5.1.2 eleven thousand two hundred fifty (11,250) series A shares, with a nominal value of one euro (EUR 1) each (the

“Series A Shares”).

5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.3 The Company may redeem its own shares.

Art. 6. Shares.
6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of

the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.

Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection

by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.

7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall

appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.

7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given

by the shareholders at a majority of three quarters of the share capital.

7.5 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of

the transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

7.6 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject

to the approval of such transfer given by the surviving shareholders at a majority of three quarters of the share capital.
Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving
spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.

Art. 8. Liquidation and sale preferences.
8.1 In case (i) of any sale of at least 50% of all shares in the Company, or a swap or a take-over of the Company in an

economically comparable way in a single or more related transactions or in close time proximity to one another, or (ii)
of the liquidation of the Company or (iii) of any sale or transfer of shares in the Company either to third parties or other
shareholders that would result in either more than 50% of the share capital or more than 50 % of the voting rights being
owned by the acquiring party/parties (change of control) as a result of one or more related acquisitions (each of the
events described in (i), (ii) and (iii) is hereinafter referred to as a “Liquidity Event”), the proceeds (“Exit Proceeds”) -
subject to Article 8.2 below - will be distributed in accordance with Article 8.3 to the shareholders pro rata to their
participation in the Liquidity Event.

8.2 On a first level (“First Level”) the respective shareholder shall receive an amount equal to its total investment

made in the Company in order to acquire the respective Series A Shares held by it, consisting of the nominal amount of
the Series A Shares acquired and any share premium and/or other capital contribution (account 115) paid by it to the
Company.

8.3 After the payments on the First Level have been made, the remaining Exit Proceeds shall be allocated on a second

level (“Second Level”) to all selling Shareholders pro rata to their participation in the Liquidity Event. Any amounts received
by any shareholder on the First Level shall reduce the amount to be allocated to such shareholder on this Second Level
provided that no shareholder shall be obliged to repay any amount received on the First Level. Irrespective of whether
or not the sale of shares is made in one Liquidity Event or after the Liquidity Event in one transaction or more transactions,
no shareholder shall receive for the sale of all of its shares (and shall repay any exceeding amount to the other share-
holders) an amount exceeding the higher of (i) its share in the total Exit Proceeds or proceeds pro rata to the shares
sold on a common equivalent basis or (ii) the amount allocated to such shareholder on the First Level and/or Second
Level from a subsequent sale. All rights related to the liquidity preference stipulated herein can only be exercised once.

8.4 The preferred allocation of Exit Proceeds on the First Level applies for the benefit of the respective shareholder

so long as the respective shareholder has not yet received the full amount that is to be allocated to such shareholder
according to the First Level.

102354

L

U X E M B O U R G

C. Decisions of the shareholders

Art. 9. Collective decisions of the shareholders.
9.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles

of association.

9.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
9.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise

conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case,
each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his
vote in writing.

9.4 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of

shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by
the sole shareholder.

Art. 10. General meetings of shareholders. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, at least

one general meeting of shareholders shall be held within six (6) months of the end of each financial year in Luxembourg
at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the convening notice of such meeting.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices
of meeting. If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived
any convening requirement, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 11. Quorum and vote.
11.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
11.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company's

shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share
capital. If this majority is not reached in a first meeting or proposed written resolution, the shareholders may be convened
a second time with the same agenda or receive such proposed written resolution a second time by registered letter,
decisions are validly adopted in so far as they are adopted by a majority of the votes validly cast whichever is the fraction
of the share capital represented.

Art. 12. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.

Art. 13. Amendments of the articles of association. Any amendment of the articles of association requires the approval

of (i) a majority of shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.

D. Management

Art. 14. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
14.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers

form a board of managers.

14.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not

expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of
association is to be construed as a reference to the “sole manager”.

14.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any

actions necessary or useful to fulfil the Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the
Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.

Art. 15. Appointment, removal and term of office of managers.
15.1 The manager(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remune-

ration and term of office.

15.2 The managers shall be appointed and may be removed from office at any time, with or without cause, by a decision

of the shareholders representing more than half of the Company's share capital.

15.3 The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two (2) different classes, being class A

managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant
shareholders resolutions and the managers be identified with respect to the class they belong.

Art. 16. Vacancy in the office of a manager.
16.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or

otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the replaced manager by the  remaining  managers  until  the  next  meeting of  shareholders which shall resolve  on  the
permanent appointment, in compliance with the applicable legal provisions.

102355

L

U X E M B O U R G

16.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company's sole manager, such vacancy must be filled without undue

delay by the general meeting of shareholders.

Art. 17. Convening meetings of the board of managers.
17.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held

at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.

17.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four (24) hours at

least in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document
being sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location
determined in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.

17.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive

any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of
managers.

Art. 18. Conduct of meetings of the board of managers.
18.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not

need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

18.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may

appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any
such meeting.

18.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either

in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.

18.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other

means of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis
and allowing an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a
participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.

18.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or

represented at a meeting of the board of managers.

18.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,

if any, shall not have a casting vote. In the event where the general meeting of shareholders has appointed different classes
of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only be validly
taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which may be
represented).

18.7. The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in

writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be
the date of the last signature.

Art. 19. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
19.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by

the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. In the event the general meeting of
shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers), such minutes
shall be signed by one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation). Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman,
if any, or by any two (2) managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of
managers (namely class A managers and class B managers), such copies or excerpts shall be signed by one (1) class A
manager and one (1) class B manager (including by way of representation).

19.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or

excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.

Art. 20. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the

signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers;
in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers
and class B managers), the Company will only be validly bound by the joint signatures of at least one (1) class A manager
and one (1) class B manager (including by way of representation) or (ii) by the joint signatures or the sole signature of
any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such
delegation.

102356

L

U X E M B O U R G

E. Audit and supervision

Art. 21. Auditor(s).
21.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company

shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.

21.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting

of shareholders.

21.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
21.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d'entreprises agréé

(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies' register and the
accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.

21.5. An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its

approval.

F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends

Art. 22. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end

on the thirty-first of December of the same year.

Art. 23. Annual accounts and allocation of profits.
23.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of

the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.

23.2. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve.

This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten
per cent (10%) of the share capital of the Company.

23.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the

contributing shareholder agrees with such allocation.

23.4 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does

not exceed ten per cent (10%) of the share capital.

23.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the

remainder of the Company's profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.

23.6 Subject to Article 8, distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they

hold in the Company.

Art. 24. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
24.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared

by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may
not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable
reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles
of association do not allow to be distributed.

24.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the share-

holders subject to the provisions of the Law and these articles of association.

G. Liquidation

Art. 25. Liquidation.
25.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the

liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders
deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided,
the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the
Company.

25.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the shareholders in proportion to the number of shares of the Company held by them.

H. Final clause - Governing law

Art. 26. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance

with the Law.

<i>Transitional provisions

1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 31 December

2014.

2. Interim dividends may be distributed during the Company's first financial year.

102357

L

U X E M B O U R G

<i>Subscription and payment

The one thousand two hundred fifty (1,250) common shares and eleven thousand two hundred fifty (11,250) series A

shares, with a nominal value of one euro (EUR 1) each, issued have been subscribed by Emerging Markets Online Food
Delivery Holding S.à r.l., aforementioned, for the price of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.00).

The shares so subscribed are fully paid-up by a contribution in cash so that the amount of twelve thousand five hundred

euro (EUR 12,500) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

The total contribution in the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) is entirely allocated to the

share capital.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be

borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately one thousand two hundred
euro.

<i>Resolutions of the sole shareholder

The incorporating shareholder, representing the entire share capital of the Company and having waived any convening

requirements, has thereupon passed the following resolutions:

1. The address of the registered office of the Company is set at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of

Luxembourg.

2. The following persons are appointed as class A manager of the Company for an unlimited term:
- Mr Christian Senitz, born in Aschersleben, Germany, on 27 January 1978, professionally residing at Johannisstrasse

20, D-10117 Berlin;

- Mr Ralf Wenzel, born in Berlin, Germany, on 8 August 1979, professionally residing at Johannisstrasse 20, D-10117

Berlin, Germany.

The following person is appointed as class B manager of the Company for an unlimited term:
- Mr Ulrich Binninger, born in Trier, Germany, on 30 August 1966, professionally residing at 19, rue des Lilas, L-8035

Strassen, Luxembourg.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,

this deed is worded in English followed by a German translation; at the request of the same appearing party and in case
of divergence between the English and the German text, the English version shall prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name

and residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausendvierzehn, am dreißigsten Mai.
Vor uns, Joseph Elvinger, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,

IST ERSCHIENEN:

Emerging Markets Online Food Delivery Holding S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach deutschem

Recht, eingetragen im Luxemburger Gesellschaft- und Handelsregister, unter der Nummer B 175738, mit Sitz in 7, avenue
J.P. Pescatore, L - 2324 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,

hier vertreten durch Alix van der Wielen, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht

ausgestellt in Berlin, Deutschland und einer Vollmacht ausgestellt in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Besagte  Vollmacht,  welche  von  der  erschienenen  Partei  und  dem  unterzeichnenden  Notar  ne  varietur  paraphiert

wurde, wird der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.

Die erschienene Partei hat den amtierenden Notar ersucht, die Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung

(société à responsabilité limitée) zu beurkunden, welche sie mit der folgenden Satzung gründen möchte:

A. Name - Zweck - Dauer - Sitz

Art. 1. Name - Rechtsform. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée)

mit dem Namen 20140519 Holding S.à r.l. (die “Gesellschaft”), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August
1915 über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Ge-

sellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder

102358

L

U X E M B O U R G

auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kontrolle
und Entwicklung ihrer Beteiligungen im Hinblick auf deren Verwertung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Art.

2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder

Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören Garantien geben,
Sicherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.

2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere

durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und
Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheine bzw. Wertpapieren.

2.4 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur vornehmen

sowie solche, welche das geistige Eigentum betreffen oder im Zusammenhang mit Grundeigentum stehen und die ihr zur
Erreichung dieser Zwecke förderlich erscheinen.

Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden,

welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird.

Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in der Stadt Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Rates der Geschäftsführer

verlegt werden. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderli-
chen Art und Weise gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer im

Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.

4.4 Sollte der Rat der Geschäftsführer entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale

Entwicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an
ihrem  Gesellschaftssitz  beeinträchtigen  könnten,  so  kann  der  Gesellschaftssitz  bis  zur  endgültigen  Beendigung  dieser
außergewöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben
keine Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes
eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) aufgeteilt in
5.1.1 ein tausendzweihundertfünfzig (1.250) Stammanteile mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Anteil

(die „Stammanteile“); und

5.1.2 elftausendzweihundertfünfzig (11.250) Anteile der Serie A mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro

Anteil (die „Serie A Anteile“).

5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-

zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.

5.3 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen.

Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit jeweils dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht über-

schreiten darf.

6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs, die Insolvenz

oder ein vergleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.

Art. 7. Anteilsregister - Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden

kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.

7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten

wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft
ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.

7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.

102359

L

U X E M B O U R G

7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern mit

einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden.

7.5 Jede Übertragung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten gemäß Artikel 1690 des Code Civil

wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung zugestimmt
hat.

7.6 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters an neue Gesellschafter nur mit Zustimmung von

Gesellschaftern mit einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden. Eine derartige Zu-
stimmung ist nicht erforderlich, wenn die Anteile an Eltern, Nachkommen oder den/die überlebende/n Ehepartner/in
übertragen werden oder jedem anderem gesetzlichen Erben des verstorbenen Gesellschafters.

Art. 8. Liquidations- und Verkaufspräferenzen.
8.1 Im Falle (i) eines Verkaufs von mindestens 50% aller Anteile an der Gesellschaft oder eines Tausches oder einer

Übernahme der Gesellschaft in wirtschaftlich vergleichbarer Weise in einer oder mehreren Transaktionen oder in zeit-
licher Nähe zueinander, oder (ii) der Liquidation der Gesellschaft oder (iii) des Verkaufs oder der Übertragung von
Anteilen an der Gesellschaft entweder an Dritte oder an andere Gesellschafter, was dazu führen würde, dass entweder
mehr als 50% des Gesellschaftskapitals oder mehr als 50% der Stimmrechte im Besitz der erwerbenden Partei bzw.
Parteien wären (change of control), als Ergebnis eines oder mehrerer verbundener Akquisitionen, (wobei jeder der unter
(i), (ii) und (iii) beschriebenen Fälle im Folgenden als „Liquiditätsereignis“ bezeichnet wird), werden die Erlöse („Exiter-
löse“) - vorbehaltlich des Artikels 8.2 - im Einklang mit Artikel 8.3 auf einer pro rata-Basis entsprechend ihrer Beteiligung
am Liquiditätsereignis an die Gesellschafter verteilt.

8.2 Auf einer ersten Ebene („Erste Ebene”) erhält der jeweilige Gesellschafter einen Betrag, welcher dem Betrag seiner

jeweiligen Gesamtinvestition in die Gesellschaft entspricht, welche er aufgebracht hat, um Anteile der Serie A zu erwerben,
bestehend aus dem Nominalwert der Anteile der Serie A und dem Agio und/oder anderen Kapitaleinlage (Konto 115 des
Standardisierten Luxemburgischen Kontenplans), die von diesem Gesellschafter an die Gesellschafter gezahlt wurden.

8.3 Nachdem die Zahlungen auf der Ersten Ebene geleistet wurden, werden die übrigen Exiterlöse auf einer zweiten

Ebene („Zweite Ebene“) an alle verkaufenden Gesellschafter auf einer pro rata-Basis entsprechend ihrer Beteiligung am
Liquiditätsereignis verteilt. Sämtliche von einem Gesellschafter auf der Ersten Ebene erhaltenen Beträge mindern den von
diesem Gesellschafter zu erhaltenden Betrag auf dieser Zweiten Ebene mit der Maßgabe, dass kein Gesellschafter zur
Rückzahlung eines auf der Ersten Ebene erhaltenen Betrags verpflichtet ist. Die Zuteilung auf der Gemeinsamen Ebene
erfolgt solange, bis alle Exiterlöse an die Gesellschafter verteilt wurden. Unabhängig davon, ob der Verkauf von Anteilen
während eines Liquiditätsereignisses oder danach in einer oder mehreren Transaktionen erfolgt oder nicht, hat kein
Gesellschafter für den Verkauf all seiner Anteile einen Betrag zu erhalten (und übersteigende Beträge an die anderen
Gesellschafter zurückzuzahlen), der höher ist, (i) als sein Anteil an der Gesamtheit der Exiterlöse oder Erlöse auf einer
pro rata-Basis zu den Anteilen, die auf einer gemeinsamen und gleichwertigen Basis verkauft wurden oder (ii) als der
Betrag, der diesem Gesellschafter auf der Ersten und/oder Zweiten Ebene aus einem späteren Verkauf zugeteilt wurde.
Sämtliche mit der hierin festgelegten Liquiditätspräferenz verbundenen Rechte können nur einmal ausgeübt werden.

8.4 Die bevorzugte Zuteilung von Exiterlösen auf der Ersten Ebene gilt zugunsten des jeweiligen Gesellschafters so

lange, wie der jeweilige Gesellschafter noch nicht den ihm auf der Ersten Ebene zustehenden Gesamtbetrag erhalten hat.

C. Entscheidungen der Gesellschafter

Art. 9. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
9.1 Die Gesellschafterversammlung ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch das Gesetz und diese Satzung

übertragen wurden.

9.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.
9.3 Falls und solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, dürfen gemeinsame Ent-

scheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung vorbehalten wären, schriftlich gefasst werden. In diesem
Fall  erhält  jeder  Gesellschafter  den  Text  der  Beschlüsse  oder  Entscheidungen  in  ausformulierter  Form  und  übt  sein
Stimmrecht schriftlich aus.

9.4 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschriften

des Abschnitts XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jeder Bezug auf die „Gesellschafter-
versammlung“ in der vorliegenden Satzung als Bezug auf den Alleingesellschafter, je nach Zusammenhang und soweit
anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingesellschafter ausgeübt.

Art. 10. Gesellschafterversammlung. Falls die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, muss jähr-

lich innerhalb von sechs (6) Monaten vor dem Ende des Geschäftsjahres mindestens eine Gesellschafterversammlung in
Luxemburg am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort abgehalten werden, wie in der Einberufungsbekanntma-
chung zu dieser Versammlung genauer bestimmt. Andere Gesellschafterversammlungen finden an dem Ort und zu der
Zeit  statt,  welcher  in  der  entsprechenden  Einberufungsbekanntmachung  genauer  bestimmt  werden.  Falls  alle  Gesell-
schafter in einer Versammlung anwesend oder vertreten sind und auf sämtliche Einberufungsformalitäten verzichtet haben,
kann die Gesellschafterversammlung auch ohne vorherige Ankündigung oder Veröffentlichung abgehalten werden.

102360

L

U X E M B O U R G

Art. 11. Quorum und Abstimmung.
11.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.
11.2 Vorbehaltlich anderer Regelungen dieser Satzung oder des Gesetzes, die ein höheres Mehrheitsverhältnis vor-

sehen, bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von Gesellschaftern, die mehr als die
Hälfte des Gesellschaftskapitals halten. Falls diese Mehrheit in einer ersten Gesellschafterversammlung oder einer ersten
schriftlichen Konsultation der Gesellschafter nicht erreicht wird, können die Anteilseigner ein weiteres Mal mit derselben
Tagesordnung einberufen werden oder per Einschreiben dieselben schriftlichen Beschlussvorschläge erhalten und Ent-
scheidungen werden wirksam mit der Mehrheit der wirksam abgegebenen Stimmen gefasst, unabhängig vom Anteil des
durch sie vertretenen Gesellschaftskapitals.

Art. 12. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.

Art. 13. Änderung der Satzung. Eine Änderung der Satzung erfordert die Zustimmung (i) einer Mehrheit der Gesell-

schafter, die mindestens (ii) eine Mehrheit von drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertritt.

D. Geschäftsführung

Art. 14. Befugnisse des alleinigen Geschäftsführers - Zusammensetzung und Befugnisse des Rates der Geschäftsführer.
14.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Ge-

schäftsführer hat, bilden diese einen Rat der Geschäftsführer.

14.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „alleiniger Ge-

schäftsführer“ nicht ausdrücklich verwendet wird, ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Rat der Geschäftsführer“
als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer“ auszulegen.

14.3 Der Rat der Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse im Namen der Gesellschaft zu handeln

und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.

Art. 15. Ernennung, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
15.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung ernannt, welche ihre Bezüge und

Amtszeit festlegt.

15.2 Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund durch einen Beschluss von Gesellschaftern, die mehr als die

Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, ernannt oder abberufen werden.

15.3 Die Gesellschafterversammlung kann die Ernennung von Geschäftsführern zwei (2) unterschiedlicher Kategorien

beschließen, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Eine solche Klassifizierung
der Geschäftsführer muss ordnungsgemäß im Protokoll der betreffenden Gesellschafterbeschlüsse festgehalten und die
Geschäftsführer der Kategorie, der sie angehören, zugeordnet werden.

Art. 16. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
16.1 Scheidet ein Geschäftsführer durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Insolvenz, Rücktritt oder aus einem anderen Grund

aus seinem Amt aus, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen die ur-
sprüngliche Amtszeit nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesellschafterversammlung ausgefüllt werden,
welche im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die endgültige Ernennung entscheidet.

16.2  Für den  Fall,  dass  der  alleinige  Geschäftsführer  aus seinem Amt  ausscheidet, muss die  frei gewordene  Stelle

unverzüglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.

Art. 17. Einladung zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
17.1 Der Rat der Geschäftsführer versammelt sich auf Einberufung eines beliebigen Geschäftsführers. Die Sitzungen

des Rates der Geschäftsführer finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.

17.2  Die  Geschäftsführer  werden  mindestens  vierundzwanzig  (24)  Stunden  vor  dem  für  die  Sitzung  anberaumten

Zeitpunkt zu jeder Sitzung des Rates der Geschäftsführer schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe
der Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Geschäftsführer
schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abgege-
ben haben, wobei eine Kopie eines solchen unterzeichneten Dokuments ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung
zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss
des Rates der Geschäftsführer bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.

17.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle

Einladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Rates
der Geschäftsführer diesen zugestimmt und diese unterzeichnen.

Art. 18. Durchführung von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
18.1 Der Rat der Geschäftsführer kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Rat der Ge-

schäftsführer kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise selbst ein Geschäftsführer sein muss
und der für die Protokollführung der Sitzungen des Rates der Geschäftsführer verantwortlich ist.

102361

L

U X E M B O U R G

18.2 Sitzungen des Rates der Geschäftsführer werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Rates der Ge-

schäftsführer  geleitet.  In  dessen  Abwesenheit  kann  der  Rat  der  Geschäftsführer  ein  anderes  Mitglied  des  Rates  der
Geschäftsführer  durch  einen  Mehrheitsbeschluss  der  anwesenden  oder  vertretenen  Mitglieder  als  Vorsitzenden  pro
tempore ernennen.

18.3 Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer teilnehmen, indem er ein anderen

Geschäftsführer schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder durch ein anderes vergleichbares Kommunikationsmittel be-
vollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Geschäftsführer kann einen
oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.

18.4 Eine Sitzung des Rates der Geschäftsführer kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein

anderes Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu
hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel
ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung gilt als am Sitz der Ge-
sellschaft abgehalten.

18.5 Der Rat der Geschäftsführer kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest die Mehrheit seiner

Mitglieder in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.

18.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Rates der Geschäftsführer

teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden,
hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme. Sofern die Gesellschafterversammlung jedoch unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden Beschlüsse des Rates der Geschäftsführer nur dann wirksam gefasst, wenn sie von der Mehrheit
der Geschäftsführer einschließlich mindestens eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsführers der
Kategorie B (oder deren Vertreter) gefasst werden.

18.7 Der Rat der Geschäftsführer kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung,

per Faxschreiben, E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Jeder Geschäftsführer kann seine
Zustimmung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreffenden
Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.

Art. 19. Protokoll von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer - Protokoll der Entscheidungen des alleinigen Ge-

schäftsführers.

19.1 Das Protokoll einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer wird vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer,

falls vorhanden oder, im Falle seiner Abwesenheit, vom Vorsitzenden pro tempore und dem Schriftführer (falls vorhanden)
oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche
Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kate-
gorie B), werden solche Protokolle durch einen (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einen (1) Geschäftsführer der
Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet. Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsver-
fahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer, falls
vorhanden, oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden solche Kopien oder Auszüge durch einen (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einen (1)
Geschäftsführer der Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet.

19.2 Die Entscheidungen des alleinigen Geschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom alleinigen

Geschäftsführer unterzeichnet wird. Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet.

Art. 20. Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Um-

ständen  durch  (i)  die  Unterschrift  des  alleinigen  Geschäftsführers  oder,  für  den  Fall,  dass  die  Gesellschaft  mehrere
Geschäftsführer hat, durch die gemeinsame Unterschrift zwei (2) beliebiger Geschäftsführer wirksam verpflichtet; sofern
die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer
der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B), wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift min-
destens  eines  (1)  Geschäftsführers  der  Kategorie  A  und  eines  (1)  Geschäftsführers  der  Kategorie  B  (oder  deren
Vertreter), oder (ii) durch die gemeinsamen Unterschriften oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/
denen eine Unterschriftsbefugnis durch den Rat der Geschäftsführer übertragen worden ist, wirksam verpflichtet.

E. Aufsicht und Prüfung der Gesellschaft

Art. 21. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
21.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der

Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)). Die Gesellschafterversammlung
ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.

21.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
21.3 Die Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Recht der permanenten Überprüfung und Kontrolle aller Ge-

schäfte der Gesellschaft.

102362

L

U X E M B O U R G

21.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember

2002  betreffend  das  Handelsregister  und  die  Buchhaltung  und  den  Jahresabschluss  von  Unternehmen,  in  der  jeweils
gültigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d'entreprise agréé(s)) ernennen, entfällt
die Funktion des Rechnungsprüfers.

21.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die

Gesellschafterversammlung abberufen werden.

F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinne - Abschlagsdividenden

Art. 22. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am

einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

Art. 23. Jahresabschluss und Gewinne.
23.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Rat der Geschäftsführer erstellt im

Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und
Verlustrechnung.

23.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage

der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.

23.3  Durch  einen  Gesellschafter  erbrachte  Einlagen  in  Rücklagen  können  mit  Zustimmung  dieses  Gesellschafters

ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.

23.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage entsprechend herabgesetzt

werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.

23.5 Auf Vorschlag des Rates der Geschäftsführer bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den ge-

setzlichen  Vorschriften  und  den  Bestimmungen  dieser  Satzung  wie  der  verbleibende  Bilanzgewinn  der  Gesellschaft
verwendet werden soll.

23.6 Gemäß Artikel 8, Ausschüttungen an die Gesellschafter erfolgen proportional zur Anzahl der von ihnen an der

Gesellschaft gehaltenen Anteile.

Art. 24. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
24.1 Der Rat der Geschäftsführer kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche

vom Rat der Geschäftsführer vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur
Verfügung stehen. Der ausschüttbare Betrag darf nicht die Summe der seit dem Ende des vergangenen Geschäftsjahres
angefallenen Gewinne, gegebenenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne und ausschüttbare Rücklagen, beziehungs-
weise vermindert durch vorgetragene Verluste oder Summen, die einer Rücklage zugeführt werden, welche nach dem
Gesetz von 1915 oder dieser Satzung nicht ausgeschüttert werden darf, übersteigen.

24.2 Das Agio, andere Kapitalreserven und andere ausschüttbare Rücklagen können, im Einklang mit den Bestimmungen

des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung, frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

G. Liquidation

Art. 25. Liquidation.
25.1 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Abwicklung durch

einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, die über die
Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit nichts anderes
bestimmt wird haben die Liquidatoren die weitestgehenden Rechte für die Verwertung der Vermögenswerte und die
Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

25.2 Der sich nach Verwertung der Vermögenswerte und Tilgung der Verbindlichkeiten ergebende Überschuss wird

an die Gesellschafter proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehaltenen Anteile verteilt.

H. Schlussbestimmungen - Anwendbares recht

Art. 26. Anwendbares Recht. Für alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten gelten die Regelungen des

Gesetzes von 1915.

<i>Übergangsbestimmungen

1. Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember

2014.

2. Abschlagsdividenden können auch während des ersten Geschäftsjahres der Gesellschaft ausgeschüttet werden.

<i>Zeichnung und Zahlung

Die eintausendzweihundertfünfzig (1.250) ausgegebenen Stammanteile und die elftausedzweihundertfünfzig (11.250)

ausgegebenen Serie A Anteile mit jeweils einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Anteil, wurden durch Emerging

102363

L

U X E M B O U R G

Markets Online Food Delivery Holding S.à r.l., vorbenannt, zum Preis von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500)
gezeichnet.

Die Einlage für so gezeichnete Anteile wurde vollständig in bar erbracht, so dass der Gesellschaft ein Betrag in Höhe

von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) zur Verfügung steht, was dem unterzeichnenden Notar nachgewiesen
wurde.

Die gesamte Einlage von in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) wird vollständig dem Gesellschafts-

kapital zugeführt.

<i>Auslagen

Die der Gesellschaft aufgrund oder im Zusammenhang mit ihrer Gründung entstandenen Kosten, Gebühren, Honorare

und Auslagen werden auf ein tausend zwei hundert Euro (EUR 1.200,-) geschätzt.

<i>Beschlüsse des Alleingesellschafters

Der Gründungsgesellschafter, welcher das gesamte Gesellschaftskapital repräsentiert und welcher auf eine formelle

Einberufungsbekanntmachung verzichtet, hat daraufhin folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Sitz der Gesellschaft ist in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
2. Die folgenden Personen werden für unbegrenzte Zeit als Geschäftsführer der Kategorie A der Gesellschaft ernannt:
- Herr Christian Senitz, geboren am 27. Januar 1978 in Aschersleben, Deutschland, geschäftsansässig in Johannisstrasse

20, D-10117 Berlin, Deutschland.

- Herr Ralf Wenzel, geboren am 8. August 1979 in Berlin, Deutschland, geschäftsansässig in Johannisstrasse 20, D-10117

Berlin, Deutschland.

Die folgende Person wird für unbegrenzte Zeit als Geschäftsführer der Kategorie B der Gesellschaft ernannt:
- Herr Ulrich Binninger, geboren am 30. August 1966 in Trier, Deutschland, geschäftsansässig in 19, rue des Lilas,

L-8035 Strassen, Luxemburg.

Worüber diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen wurde.
Der beurkundende Notar, welcher die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit auf Ersuchen der erschienenen

Partei, dass diese Urkunde auf Anfrage der erschienenen Partei auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen
Übersetzung. Auf Ersuchen derselben erschienenen Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen
und dem deutschen Text, soll die englische Fassung vorrangig sein.

Nachdem das Dokument dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei verlesen wurde, welche dem Notar mit Na-

men, Vornamen und Wohnsitz bekannt ist, hat der Bevollmächtigte die Urkunde zusammen mit dem Notar unterzeichnet.

Signé: A. VAM DER WIELEN, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils le 2 juin 2014. Relation:LAC/2014/25411. Reçu soixante quinze euros (EUR

75,-).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

Référence de publication: 2014082736/636.
(140096996) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2014.

Tilad Bavaria Investment Company Limited, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 179.614.

<i>Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 6 juin 2014

Le siège social a été transféré de L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte à L-2453 Luxem-

bourg, 6, rue Eugène Ruppert.

Veuillez noter que l'adresse professionnelle de Monsieur Frank PLETSCH, Monsieur Mark GORHOLT et Madame

Urszula PRZYBYSLAWSKA, gérants, se situe désormais au L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

Veuillez noter que le siège social de l'associée unique, Tilad Bavaria Holding Company Limited, a changé et se trouve

désormais au L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, depuis le 6 juin 2014.

Luxembourg, le 11 juin 2014.

Pour extrait et avis sincères et conformes
<i>Pour Tilad Bavaria Investment Company Limited
Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2014081910/18.
(140096471) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2014.

102364

L

U X E M B O U R G

JAB Consumer Fund Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 5, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 187.699.

STATUTES

In the year two thousand and fourteen, on the twentieth day of May.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

JAB Partners S.à r.l., a Luxemburgish company whose registered office is at 5, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg, represented by Flora Gibert, employee, residing in Luxembourg City, by virtue of a proxy given
privately,

and
Mr Philip von Wulffen, a German resident professionally residing at 5, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, Grand Duchy

of Luxembourg, represented by Flora Gibert, employee, residing in Luxembourg City, by virtue of a proxy given privately,

The proxies given, signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall remain annexed to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, represented as hereabove stated, have requested the notary to state the following articles of

incorporation of a société à responsabilité limitée governed by the relevant laws and the present articles of incorporation.

<i>Definitions

The following terms shall have the meaning as set out hereafter whenever used herein with initial capital letters:
"2010 Law" means the Luxembourg law dated 17 December 2010, relating to undertakings for collective investment,

as amended from time to time;

"AIFM" means an alternative investment fund manager within the meaning of Directive 2011/61/EU and Chapter 2 of

the AIFM Law "AIFM Law" means the Luxembourg law dated 12 July 2013 on alternative investment fund managers;

"Articles" means the present articles of incorporation;
"Business Day" means a day on which the banks are open for business in Luxembourg for the full day (excluding

Saturdays, Sundays, public holidays and bank holidays);

"Euro"  or  "EUR"  means  the  lawful  currency  of  the  European  Union  member  States  that  have  adopted  the  single

currency in accordance with the Treaty establishing the European Community as amended by the Treaty on European
Union and as amended by the Treaty of Amsterdam;

"Management Company Board" means the board of Managers of the Management Company;
"Manager" means a manager appointed to the Management Company Board in accordance with these Articles or as

the case may be a member of the Management Company Board;

"SICAR" means JAB Consumer Fund SCA SICAR, a Luxembourg investment company in risk capital (société d'inves-

tissement en capital à risque, SICAR).

"Share(s)" means the shares issued by the Management Company and any share issued in exchange for those shares

or by way of conversion or reclassification, and any shares representing or deriving from those shares as a result of any
increases in or reorganization or variation of the capital of the Management Company; and

"Shareholder" means a holder of Shares.

Title I. Name, Purpose, Duration, Registered Office

Art. 1. There is hereby formed by the present and all persons and entities who may become Shareholders in future a

company in the form of a société à responsabilité limitée under the name of “JAB Consumer Fund Management S.à
r.l.” (hereinafter referred to as the "Management Company").

Art. 2. In accordance with Article 125-2 of the 2010 Law, the purpose of the Management Company is to act as the

designated management company and AIFM of the SICAR.

The activities of the Management Company as alternative investment fund manager will be limited to those referred

to in Annex I of the AIFM Law (i.e. portfolio management and/or risk management of the SICAR, administrative and
marketing services and activities related to the assets of the SICAR).

The Management Company shall carry out any activities connected with the management, administration and promo-

tion of the SICAR. In particular, it may, on behalf of the SICAR, enter into any contract, purchase, sell, exchange and
deliver any securities, property or real estate assets and, more generally, assets constitutive of authorised investments
of the SICAR, proceed to or initiate any registrations and transfers in its name or in third parties' name in the register
of shares or debentures of any Luxembourg or foreign companies, and exercise on behalf of the SICAR and the holders
of units or shares of the SICAR, all rights and privileges, especially all voting rights attached to the securities constituting

102365

L

U X E M B O U R G

the assets of the SICAR. The Management Company may further incorporate and/or acquire shares or other securities
in or issued by any of its subsidiary companies for the account of the SICAR. The foregoing powers shall not be considered
as exhaustive, but only as declaratory.

In addition, under the conditions and within the limits laid down by Luxembourg laws and regulations, the Management

Company may also enter into the following transactions for the account of the SICAR, it being understood that the
Management Company will not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would
be considered as a regulated activity of the financial sector within the meaning of the law of 5 April 1993 on the financial
sector:

- to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility;
- to advance, lend or deposit equity, bonds, notes, promissory notes, cash, cash equivalent instruments and other

equity and/or debt instruments;

- to enter into any guarantee, pledge or any other form of security within the limits of and in accordance with the

provisions of Luxembourg Law.

The Management Company may also carry out any activities connected directly or indirectly to, and/or deemed useful

and/or necessary for the accomplishment of its object, remaining, however, within the limitations set forth, but to the
largest extent permitted by the provisions of Article 125-2 of the 2010 Law and Article 5.2 of the AIFM Law.

Art. 3. The Management Company is formed for an unlimited duration.

Art. 4. The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg City, Grand Duchy of

Luxembourg. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the Mana-
gement Company Board, after having received Shareholders consent.

In the event that the Management Company Board, determines that extraordinary political or military developments

have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Management Company at its regis-
tered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be
temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures
shall have no effect on the nationality of the Management Company which, notwithstanding the temporary transfer of its
registered office abroad, will remain a Luxembourg company.

Title II. Capital, Shares

Art. 5. The Management Company's capital is fixed at two hundred and seventy-five thousand Euro (EUR 275,000.-)

represented by two thousand seven hundred and fifty (2,750) Shares of hundred Euro (EUR 100.-) each.

The capital may be increased or reduced by a resolution of the single Shareholder or by resolution of the Shareholders

of the Management Company adopted in accordance with Article 20 hereof.

Shares will only be issued in registered form and will be inscribed in the register of Shares, which is held by the

Management Company or by one or more persons on behalf of the Management Company. Such register of Shares shall
set forth the name of each Shareholder, his residence or elected domicile, the number and class of Shares held by him.

In case of a single Shareholder, the Shares held by the single Shareholder are freely transferable.
In case of plurality of Shareholders, the Shares held by each Shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the law of 10 August 1915, as amended from time to time, on commercial companies.

Title III. Shareholder meetings

Art. 6. Any regularly constituted meeting of the Shareholders of the Management Company shall represent the entire

body of Shareholders of the Management Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts
relating to the operations of Management Company.

Art. 7. In case of a single Shareholder, the single Shareholder assumes all powers conferred to the Shareholders'

meeting. Any resolutions to be taken by the single Shareholder may be taken in writing.

In case of plurality of Shareholders, the provisions of Article 8 will apply to any resolution to be taken by a meeting of

Shareholders.

Each Share is entitled to one vote.
A Shareholder may be represented (at any meeting of Shareholders) by another person, which does not need to be a

Shareholder and which might be a Manager. The proxy established to this effect may be in writing or by cable, telegram,
facsimile or e-mail transmission.

Art. 8. If legally required or if not so required upon the decision of the Management Company Board, annual general

meetings of Shareholders of the Management Company shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg
at the registered office of the Management Company, or such other place in Luxembourg as may be specified in the notice
of the meeting. Such annual general meetings may be held abroad if, in the judgement of the Management Company Board,
exceptional circumstances so require.

The Management Company Board, may convene other meetings of Shareholders to be held at such place and time as

may be specified in the respective notices of meetings.

102366

L

U X E M B O U R G

The quorum and delays required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of Shareholders of

the Management Company, unless otherwise provided herein.

Except as otherwise required by law or provided herein, resolutions at a meeting of Shareholders duly convened will

be passed by simple majority of those present and voting.

The general meeting of Shareholders shall be called by the Management Company Board, by notices containing the

agenda and which will be published as required by law.

The Management Company Board, will prepare the agenda, except if the meeting takes place due to the written request

of Shareholders provided for by law; in such case the Management Company Board, may prepare an additional agenda.

If all of the Shareholders are present or represented at a meeting of Shareholders, and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

The matters dealt with by the meeting of Shareholders are limited to the issues contained in the agenda which must

contain all issues prescribed by law as well as to issues related thereto, except if all the Shareholders agree to another
agenda. In case the agenda should contain the nomination of Managers or of the auditor, the names of the eligible Managers
or of the auditors will be inserted in the agenda.

Title IV. Administration

Art. 9. The Management Company shall be managed by at least three Manager(s). The Managers will constitute a

Management Company Board.

The Manager(s) need not be Shareholders of the Management Company.
The Manager(s) shall be elected by the general meeting of Shareholders for a period as determined by such general

meeting of Shareholders and until their successors are elected and take up their functions. Upon expiry of its mandate,
a Manager may seek reappointment.

In the event of a vacancy in the office of a Manager because of death, retirement or otherwise, the remaining Managers

may meet and may elect, by majority vote, a Manager to fill such vacancy until the next general meeting of Shareholders.

Art. 10. The Management Company Board shall choose from among its members a chairman.
The chairman shall preside at all meetings of the Management Company Board but in his absence or incapacity to act,

the Managers present may appoint anyone of their number to act as chairman for the purposes of the meeting.

The Management Company Board may also choose a secretary, who need not be a Manager and who shall be res-

ponsible for keeping the minutes of the meetings of the Management Company Board and of the Shareholders.

The Management Company Board, may from time to time appoint officers of the Management Company, including a

day-to-day manager, a general manager and any assistant managers or other officers considered necessary for the ope-
ration and management of the Management Company. In particular, the Management Company Board will appoint, in
accordance with the requirements of the AIFM Law, at least two officers as "dirigeants" to effectively conduct the business
of the Management Company. Any such appointment may be revoked at any time by the Management Company Board.
Officers need not to be Managers or Shareholders of the Management Company. The officers appointed, unless otherwise
stipulated herein, shall have the powers and duties given to them by the Management Company Board.

The Management Company Board shall meet upon call by the chairman, or any two Managers, at the place indicated

in the notice of meeting.

Written notice, containing an agenda which sets out any points of interest for the meeting, of any meeting of the

Management Company Board shall be given to all Managers at least 3 calendar days prior to the beginning of such meeting,
except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of
the meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by telegram, facsimile or e-mail transmission of each
Manager. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule
previously adopted by resolution of the Management Company Board.

Any Manager may act at any meeting of the Management Company Board by appointing, in writing or by telegram,

facsimile or e-mail transmission, another Manager as his proxy.

Any Manager who is not physically present at the location of a meeting may participate in such a meeting of the

Management Company Board by remote conference facility or similar means of communication equipment, whereby all
persons participating in the meeting can hear each other, and participating in a meeting by such means shall constitute
presence in person at such meeting.

The Management Company Board can deliberate or act validly only if at least two Managers are present at a meeting

of the Management Company Board. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the Managers present or
represented.

Resolutions signed by all Managers will be as valid and effectual as if passed at a meeting duly convened and held. Such

signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letters,
telegrams, facsimile or e-mail transmissions.

The minutes of any meeting of the Management Company Board shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the chairman pro tempore who presided at such meeting or by any two Managers.

102367

L

U X E M B O U R G

Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by

the chairman or by any two Managers or by a Manager together with the secretary or the alternate secretary.

Art. 11. The Management Company Board shall have power to determine the course and conduct of the management

and business affairs of the Management Company.

It is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the interests of the

Management Company. All powers not expressly reserved by law or by these Articles to the general meeting of Share-
holders fall within the competence of the Management Company Board.

Art. 12. The Management Company shall be bound by the joint signature of any two Managers of the Management

Company, or by the individual signature of the day-to-day manager or by the individual signature of an officer or any
person(s) to whom such signatory authority has been delegated by the Management Company Board.

Art. 13. The Management Company Board, may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of

the Management Company, including the right to sign on behalf of the Company, and its powers to carry out acts in
furtherance of the corporate policy and purpose, to officers of the Management Company or to other persons, which at
their turn may delegate their powers if they are authorised to do so by the Management Company Board.

Art. 14. No contract or other transaction which the Management Company and any other company or firm might

enter into shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Managers or officers of the Management
Company is interested in such other company or firm by a relation, or is a director, officer or employee of such other
company or legal entity, provided that the Management Company obliges itself to never knowingly sell or lend assets of
UCIs it manages to any of its directors or officers or any company or firm controlled by them.

In the event that any Manager or officer of the Management Company may have any personal interest in any contract

or transaction of the Management Company other than that arising out of the fact that he is a Manager, officer or employee
or holder of securities or other interests in the counter-party, such Manager or officer shall make known to the Mana-
gement Company Board such personal interest and shall not consider or vote upon any such contract or transaction.
Such contract or transaction, and such Manager's or officer's personal interest therein, shall be reported to the next
succeeding meeting of Shareholders.

Art. 15. The Management Company may indemnify any Manager or officer and his heirs, executors and administrators,

against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made
a party by reason of his being or having been a Manager or officer of the Management Company or, at its request, of any
other company of which the Management Company is a unitholder or a creditor and which he is not entitled to be
indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be
liable for gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection
with such matters covered by the settlement as to which the Management Company is advised by counsel that the person
to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other
rights to which he may be entitled.

Title V. Accounting, Distributions

Art. 16. The operations of the Management Company and its financial situation as well as its books shall be supervised

by one or more auditor(s) qualifying as reviseur d'enterprises agréé(s). The auditor(s) shall be elected by the Shareholders
at the annual general meeting of Shareholders for a period which shall end on the day of the following annual general
meeting of Shareholders which decides upon the appointment of its (their) successor(s).

Art. 17. The accounting year of the Management Company shall begin on 1 

st

  January  and  shall  terminate  on  31

December of each year.

Art. 18. From the annual net profit of the Management Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve

required by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent
(10%) of the capital of the Management Company as stated in Article 5 hereof or as increased or reduced from time to
time in accordance with Article 5 hereof.

The general meeting of Shareholders shall decide each year how the remainder of the annual net profit shall be allocated

and may declare dividends from time to time or instruct the Management Company Board, to do so.

The Management Company Board, may within the conditions set out by law unanimously resolve to pay out interim

dividends.

Title VI. Winding up, Liquidation

Art. 19. In the event of a winding-up of the Management Company, the liquidation shall be carried out by one or several

liquidators. Liquidators may be physical persons or legal entities and are named by the meeting of Shareholders deciding
such winding-up and which shall determine their powers and their compensation.

102368

L

U X E M B O U R G

Title VII. Amendments

Art. 20. These Articles of Incorporation may be amended from time to time by a meeting of Shareholders, subject to

the respect of the quorum and majority requirements provided by Luxembourg law.

Art. 21. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies, as amended from time to time, and, to the extent applicable, the 2010 Law
and the AIFM Law.

<i>Transitory disposition

The first accounting year shall commence on the date of incorporation of the Management Company and shall terminate

on 31 December 2014.

<i>Subscription and Payment

The capital of the Management Company is subscribed as follows:
- JAB Partners S.à r.l., above named, subscribes for two thousand six hundred and forty-four (2,644) shares, resulting

in a total payment of two hundred and sixty-four thousand four hundred Euro (EUR 264,400.-), and

- Mr Philip von Wulffen, above named, subscribes for one hundred and six (106) shares, resulting in a total payment

of ten thousand six hundred Euro (EUR 10,600.-).

Evidence of the above payments, was given to the undersigned notary.

<i>Expenses

The expenses which shall be borne by the Management Company as a result of its incorporation are estimated at

approximately two thousand Euro.

<i>General Meeting of Shareholders

The above named persons representing the entire subscribed capital and exercising the powers devolved to the meet-

ing, passed the following resolutions:

(i) The following are elected as Managers for a term to expire at the close of the annual general meeting of Shareholders

which shall deliberate on the annual accounts as at 31 December 2014:

- Mr Joachim Creus, residing professionally at 5 rue Goethe, L-1637 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
- Mr Markus Hopmann, professionally residing at Ludwig-Bertram-Strasse 8+10, 67059 Ludwigshafen, Germany;
- Mr David Bell, professionally residing at 2200 Pennsylvania Avenue, NW, Washington DC 20037, United States;
- Mr Philip von Wulffen, professionally residing at 5, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

and

- Mr Axel Bhat, professionally residing at 2200 Pennsylvania Avenue, NW, Washington DC 20037, United States
(ii) The following is elected as independent auditor for a term to expire at the close of the annual general meeting of

Shareholders which shall deliberate on the annual accounts as at 31 December 2014: KPMG Luxembourg S.à r.l. 9, Allée
Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

(iii) The registered office of the Management Company is set at 5 rue Goethe, L-1637 Luxembourg.

Whereof, this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the above named

persons, this deed is worded in English, followed by a German version; at the request of the same appearing persons, in
case of divergence between the English and the German text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by names, surnames, status and resi-

dence, the person appearing signed together with the notary the present original deed.

Folgt die deutsche Übersetzung vorherstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendvierzehn, am zwanzigsten Mai.
Vor Maître Joseph Elvinger, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Erschienen die folgenden Personen:

JAB Partners S.à r.l., eine luxemburgische Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit

Sitz in 5, rue Goethe, L-1637 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, vertreten durch Flora Gibert, geschäftsansässig
in Luxemburg-Stadt, aufgrund einer erteilten Vollmacht, und

Herr Philip von Wulfen, ein deutsche Staatsbürger geschäftsansässig in 5, rue Goethe, L-1637 Luxemburg, Großher-

zogtum Luxemburg, vertreten durch Flora Gibert, geschäftsansässig in Luxemburg-Stadt, aufgrund einer erteilten Voll-
macht.

102369

L

U X E M B O U R G

Die privatschriftlich erteilten Vollmachten, die von den erschienenen Parteien und dem unterzeichnenden Notar "ne

varietur" unterzeichnete Vollmacht bleibt dieser Urkunde beigefügt und ist zusammen mit dieser bei der zuständigen
Registerstelle einzureichen.

Die wie vorstehend beschriebenen vertretenen erschienenen Parteien haben den Notar gebeten, die nachstehende

Satzung (articles of incorporation) einer den einschlägigen Gesetzen sowie den Bestimmungen dieser Satzung unterlie-
genden Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) zu Protokoll zu nehmen.

<i>Definitionen

Die folgenden Begriffe haben, wen sie mit großen Anfangsbuchstaben geschrieben sind, die ihnen jeweils zugeordnete

Bedeutung:

"Gesetz von 2010" ist das luxemburgische Gesetz vom 17. Dezember 2010 bezüglich Organismen für gemeinsame

Anlagen in seiner jeweils geltenden Fassung.

"AIFM" ist ein Verwalter alternativer Investmentfonds im Sinne der Richtlinie 2011/61/EU und Kapitel 2 des AIFM

Gesetzes.

"AIFM Gesetz" ist das luxemburgische Gesetz vom 12. Juli 2013 bezüglich Verwalter alternativer Investmentfonds.
"Satzung" ist die vorliegende Satzung.
"Geschäftstag" ist ein Tag, an dem die Banken in Luxemburg für den gesamten Tag geöffnet sind (ausgenommen sams-

tags, sonntags und feiertags).

"Euro" oder "EUR" ist die gesetzliche Währung derjenigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die gemäß dem

Vertrag über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft, geändert durch den Vertrag über die Europäische Union und
den Vertrag von Amsterdam, die gemeinsame Währung eingeführt haben.

"Rat der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft" ist, der Rat der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft.
"Geschäftsführer" ist der Geschäftsführer, der gemäß dieser Satzung zum Mitglied des Rates der Geschäftsführung

bestellten Geschäftsführer bzw. ein Mitglied des Rates der Geschäftsführung.

"SICAR" ist die JAB Consumer Fund SCA SICAR, eine Luxemburger Investmentgesellschaft zur Anlage in Risikokapital

(société d'investissement en capital à risque, SICAR).

"Gesellschaftsanteil(e)" sind die von der Verwaltungsgesellschaft ausgegebenen Anteile sowie im Tausch gegen solche

Anteile oder aufgrund einer Umwandlung oder Reklassifizierung ausgegebene Anteile sowie Anteile, die aufgrund von
Kapitalerhöhungen, Umwandlungen oder Reklassifizierung für diese Anteilen stehen oder aus ihnen hervorgehen.

"Gesellschafter" ist ein Inhaber von Anteilen.

Abschnitt I. Name, Zweck, Dauer, Sitz

Art. 1. Hiermit wird durch die gegenwärtigen und künftigen Gesellschafter eine Gesellschaft in der Rechtsform einer

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit Namen „JAB Consumer Fund Management
S.à r.l.“ (nachstehend "Verwaltungsgesellschaft" genannt) gegründet.

Art. 2. Im Einklang mit Artikel 125-2 des Gesetzes von 2010 ist der Geschäftszweck der Verwaltungsgesellschaft die

Tätigkeit als die bestimmungsgemäße Verwaltungsgesellschaft und als Verwalter alternativer Investmentfonds der SICAR.

Die Tätigkeiten der Verwaltungsgesellschaft beschränken sich auf die in Annex I des AIFM Gesetzes beschriebenen

Tätigkeiten (zum Beispiel Portfolioverwaltung und/oder Risikoverwaltung, administrative Tätigkeiten, Vertrieb und Tä-
tigkeiten im Zusammenhang mit den Vermögenswerten der SICAR).

Die Verwaltungsgesellschaft wird sämtliche mit der Geschäftsführung, Verwaltung und Vermarktung der SICAR ver-

bundenen Tätigkeiten durchführen. Sie kann im Namen der SICAR Verträge schließen, Wertpapiere oder andere zulässige
Vermögenswerte erwerben, veräußern, tauschen und übergeben, kann im Namen der SICAR und der Anteilinhabern der
SICAR Eintragungen und Übertragungen vornehmen lassen und deren Rechte und Vorrechte ausüben, wie insbesondere
die Ausübung von mit den Wertpapieren, die die Vermögenswerte der SICAR bilden, verbundenen Stimmrechten. Die
Verwaltungsgesellschaft kann desweiteren im Namen der SICAR Tochtergesellschaften gründen und/oder Anteile oder
andere zulässige Vermögenswerte an Tochtergesellschaften erwerben oder durch die Tochtergesellschaft ausgeben. Die
vorstehende Aufzählung ist nicht als abschließend, sondern als beispielhaft anzusehen.

Desweiteren kann die Verwaltungsgesellschaft unter den vorgesehenen Bedingungen und Beschränkungen nach Lu-

xemburger Recht die folgenden Transaktionen im Namen der SICAR durchführen, insofern keine dieser Transaktionen
dazu führt, dass die Verwaltungsgesellschaft eine Tätigkeit ausübt, welche als regulierte Tätigkeit des Finanzsektors im
Sinne des Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor aufzufassen ist:

- die Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder jede andere Form von Kreditvereinbarungen
- das Vorlegen, Verleihen und Pfänden von Anteilskapital, Anleihen, Darlehen, Schuldscheindarlehen, Bargeld, bargel-

dähnliche Instrumente und andere Anteils- oder Schuldinstrumente

- das Eingehen jedweder Garantie, Bürgschaft oder jedweder anderer Form einer Sicherheit innerhalb der Beschrän-

kungen und im Einklang mit Vorschriften nach luxemburgischen Recht

102370

L

U X E M B O U R G

Die Verwaltungsgesellschaft kann sämtliche Tätigkeiten ausüben, die sie für die Erfüllung ihres Zwecks als nützlich

erachtet und die im Einklang mit Artikel 125-2 des Gesetzes von 2010 und Artikel 5.2 des AIFM Gesetzes stehen.

Art. 3. Die Verwaltungsgesellschaft wird für unbestimmte Zeit gegründet.

Art. 4. Der Sitz der Verwaltungsgesellschaft ist in der Gemeinde Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg. Nie-

derlassungen oder Büros können aufgrund eines Beschlusses des Rates der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft
gegründet werden, wobei solche Beschlussfassungen unter dem Vorbehalt der vorherigen schriftlichen Zustimmung der
Gesellschafter stehen.

Für den Fall, dass der Rat der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft befindet, dass außergewöhnliche politische

oder militärische Umstände eingetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, die die üblichen Tätigkeiten der Verwal-
tungsgesellschaft an ihrem Sitz stören oder die Kommunikation zwischen dem Sitz und im Ausland ansässigen Personen
erschweren könnten, kann der Sitz vorübergehend solange ins Ausland verlagert werden, bis die außergewöhnlichen
Umstände nicht mehr vorherrschen. Solche vorübergehenden Maßnahmen haben keinen Einfluss auf die Nationalität der
Gesellschaft, die ungeachtet einer vorübergehenden Verlagerung ihres Sitzes ins Ausland, eine Gesellschaft nach luxem-
burgischem Recht bleibt.

Abschnitt II. Kapital, Gesellschaftsanteile

Art. 5. Das Kapital der Verwaltungsgesellschaft ist auf zweihundertfünfundsiebzigtausend Euro (EUR 275,000.-) fest-

gelegt und in zweitausendsiebenhundertundfünfzig (2.750) Gesellschaftsanteile mit einem Wert von hundert Euro (EUR
100.-) je Anteil aufgeteilt.

Das Kapital kann aufgrund eines gemäß Artikel 20 dieser Satzung getroffenen Beschlusses des Alleingesellschafters

oder der Gesellschafter der Verwaltungsgesellschaft erhöht oder herabgesetzt werden.

Gesellschaftsanteile werden nur als Namensanteile ausgegeben und sind ins Anteilsregister einzutragen, das von der

Verwaltungsgesellschaft oder von einer oder mehreren Personen im Namen der Verwaltungsgesellschaft geführt wird. In
diesem Anteilsregister wird der Name des Gesellschafters, sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort, die Nummer
und die Klasse der von ihm gehaltenen Gesellschaftsanteile vermerkt.

Sofern  die  Verwaltungsgesellschaft  einen  Alleingesellschafter  hat,  sind  die  von  dem  Alleingesellschafter  gehaltenen

Gesellschaftsanteile frei übertragbar.

Sofern die Verwaltungsgesellschaft mehrere Gesellschafter hat, können die von jedem Gesellschafter gehaltenen Ge-

sellschaftsanteile gemäß den Bestimmungen von Artikel 189 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaf-
ten in seiner jeweils geltenden Fassung übertragen werden.

Abschnitt III. Gesellschafterversammlungen

Art. 6. Jede ordnungsgemäß einberufene Versammlung der Gesellschafter der Verwaltungsgesellschaft gilt als Vertre-

tung sämtlicher Gesellschafter der Verwaltungsgesellschaft. Sie verfügt über größtmögliche Befugnisse, mit der Geschäfts-
tätigkeit der Verwaltungsgesellschaft verbundene Handlungen anzuordnen, durchzuführen oder zu bewilligen.

Art. 7. Sofern die Verwaltungsgesellschaft einen Alleingesellschafter hat, stehen diesem sämtliche, der Gesellschafter-

versammlung übertragenen Befugnisse zu. Von dem Alleingesellschafter zu fassende Beschlüsse können schriftlich gefasst
werden.

Sofern die Verwaltungsgesellschaft mehrere Gesellschafter hat, gelten die Bestimmungen von Artikel 8 für sämtliche,

von einer Gesellschafterversammlung zu fassenden Beschlüsse.

Jedes Geschäftsanteil gewährt eine Stimme.
Ein Gesellschafter kann sich (auf Gesellschafterversammlungen) von einer anderen Person vertreten lassen, die kein

Gesellschafter sein muss und ein Geschäftsführer sein kann. Eine zu diesem Zweck gewährte Vollmacht kann schriftlich,
per Telegramm, per Fernschreiben, per Fax oder E-Mail erteilt werden.

Art. 8. Sofern kraft Gesetz erforderlich oder, andernfalls, aufgrund einer Entscheidung des Rates der Geschäftsführung

der Verwaltungsgesellschaft, werden die jährlichen Gesellschafterversammlungen der Verwaltungsgesellschaft gemäß lu-
xemburgischen  Recht  am  Sitz  der  Verwaltungsgesellschaft  in  Luxemburg  oder  einem  anderen,  in  der  Einladung  zur
Versammlung genannten Ort abgehalten. Solche jährlichen Gesellschafterversammlungen können im Ausland abgehalten
werden, wenn der Rat der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft dies aufgrund des Vorliegens außergewöhnlicher
Umstände für erforderlich hält.

Der Rat der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft, kann weitere Gesellschafterversammlungen einberufen,

die an den in den jeweiligen Einladungen genannten Orten und zu den darin ebenfalls genannten Zeiten abgehalten werden.

Vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen in dieser Satzung gelten im Hinblick auf die Fristen für Einladungen zu

Gesellschafterversammlungen und deren Beschlussfähigkeit die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen.

Vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher Bestimmungen oder Bestimmungen dieser Satzung sind auf einer ordnungs-

gemäß einberufenen Gesellschafterversammlung zu fassende Beschlüsse mit der einfachen Mehrheit der anwesenden und
sich an der jeweiligen Abstimmung beteiligenden Gesellschafter zu fassen.

102371

L

U X E M B O U R G

Die jährlichen Gesellschafterversammlungen sind vom Rat der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft durch

Versendung von Einladungen einzuberufen, die die Tagesordnung enthalten und die gemäß den einschlägigen gesetzlichen
Bestimmungen zu veröffentlichen sind.

Der Rat der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft wird die Tagesordnung erstellen, es sei denn, eine Ver-

sammlung findet auf schriftliches Verlangen der Gesellschafter gemäß den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen statt;
in einem solchen Fall kann der Rat der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft eine weitere Tagesordnung erstellen.

Sofern bei einer Gesellschafterversammlung alle Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und erklären, dass sie

über die Tagesordnung der Versammlung informiert worden sind, kann eine Versammlung ohne vorherige Einladung oder
Veröffentlichung abgehalten werden.

Die Angelegenheiten, die von einer Gesellschafterversammlung behandelt werden, sind auf die in der Tagesordnung

genannten Punkte zu beschränken, wobei alle gesetzlich vorgeschriebenen und mit diesen zusammenhängende Punkte zu
behandeln sind, es sei denn, alle Gesellschafter einigen sich auf eine andere Tagesordnung. Sofern die Bestellung von
Geschäftsführern oder eines Abschlussprüfers auf der Tagesordnung steht, sind die Namen der zur Wahl stehenden
Geschäftsführer, oder Abschlussprüfer in die Tagesordnung aufzunehmen.

Abschnitt IV. Verwaltung

Art. 9. Die Geschäfte der Verwaltungsgesellschaft werden von mindestens drei (3) Geschäftsführern geführt. Sie bilden

den Rat der Geschäftsführung.

Der bzw. die Geschäftsführer müssen keine Gesellschafter der Verwaltungsgesellschaft sein.
Der bzw. die Geschäftsführer werden von der jährlichen Gesellschafterversammlung für einen von dieser bestimmten

Zeitraum gewählt, bis ihre Nachfolger gewählt sind und ihr Amt übernehmen. Nach Ablauf seiner Amtszeit kann sich ein
Geschäftsführer wieder zur Wahl stellen.

Im Fall, dass der Posten eines Geschäftsführers aufgrund des Todes, der Eintritts in den Ruhestand eines Geschäfts-

führers oder aus anderen Gründen vakant wird, können sich die verbleibenden Geschäftsführer versammeln und mit
einfacher Mehrheit einen Geschäftsführer wählen, der eine solche Vakanz bis zur nächsten jährlichen Gesellschafterver-
sammlung ausfüllt.

Art. 10. Der Rat der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft ernennt aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden.
Der Vorsitzende führt den Vorsitz sämtlicher Gesellschafterversammlungen der Verwaltungsgesellschaft. Sofern der

Vorsitzende bei einer Versammlung abwesend oder nicht handlungsfähig ist, können die Geschäftsführer aus ihrer Mitte
einen Vorsitzenden für die Zwecke der jeweiligen Versammlung ernennen.

Der Rat der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft kann einen Sekretär ernennen, der kein Geschäftsführer

sein muss und für die Führung des Protokolls von Versammlungen des Rates der Geschäftsführung und von Gesellschaf-
terversammlungen verantwortlich ist.

Der Rat der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft kann jeweils Bevollmächtigte („Officers“) der Gesellschaft

ernennen, einschließlich eines Day-to-Day Managers, eines General Managers, eines Assistant Managers oder sonstiger
Bevollmächtigte, die im Hinblick auf den Betrieb und die Verwaltung der Verwaltungsgesellschaft für erforderlich gehalten
werden. Im Besonderen wird der Rat der Geschäftsführung, im Einklang mit den Bestimmungen des AIFM Gesetzes,
mindestens 2 Bevollmächtigte als "dirigeants" einstellen, welche die Geschäfte der Verwaltungsgesellschaft tatsächlich
leiten. Eine solche Einstellung kann zu jeder Zeit durch den Rat der Geschäftsführung widerrufen werden. Bevollmächtigte
müssen keine Geschäftsführer, oder Gesellschafter der Verwaltungsgesellschaft sein. Die ernannten Bevollmächtigte ha-
ben die ihnen vom Rat der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft zugewiesenen Befugnisse und Pflichten.

Der Rat der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft versammelt sich auf Einladung des Vorsitzenden oder von

zwei Geschäftsführern an dem in der jeweiligen Einladung genannten Ort.

Sämtlichen Geschäftsführern ist mindestens drei Kalendertage vor Beginn einer solchen Versammlung eine schriftliche

Einladung zusammen mit einer Tagesordnung zu übermitteln, in der sämtliche Geschäftsordnungspunkte aufgeführt sind.
Von dieser Frist kann in dringenden Ausnahmefällen abgewichen werden, in denen die näheren Umstände in der Einladung
auszuführen sind. Auf eine Einladung kann verzichtet werden, sofern sämtliche Geschäftsführer einer solchen Verfah-
rensweise schriftlich, per Telegramm, Fax oder E-Mail zustimmen. Für einzelne Versammlungen, deren Zeit und Ort vorab
durch Gesellschafterbeschluss festgelegt worden sind, ist keine weitere Einladung erforderlich.

Geschäftsführer können sich bei Versammlungen des Rates der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft vertre-

ten lassen, indem sie einen anderen Geschäftsführer schriftlich, per Telegramm, Fax oder E-Mail zu ihrem Vertreter
ernennen.

Geschäftsführer, die an einem Versammlungsort nicht physisch anwesend sind, können an einer Versammlung des

Rates der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft per Konferenzschaltung oder auf einem ähnlichen Kommunika-
tionsweg teilnehmen, wobei sich alle Teilnehmer einer solchen Versammlung gegenseitig hören können müssen, und eine
Teilnahme an einer solchen Versammlung kommt einer persönlichen Teilnahme gleich.

Eine Versammlung der Geschäftsführer der Verwaltungsgesellschaft kann nur wirksam beraten und handeln, wenn

mindestens zwei Geschäftsführer bei einer Versammlung des Rates der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft
anwesend sind. Beschlüsse sind mit einfacher Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer zu fassen.

102372

L

U X E M B O U R G

Von sämtlichen Geschäftsführern unterzeichnete Beschlüsse sind genauso gültig und wirksam wie bei einer ordnungs-

gemäß  einberufenen  und  abgehaltenen  Versammlung  gefasste  Beschlüsse.  Solche  Unterschriften  können  auf  einem
einzigen Dokument oder auf mehreren Ausfertigungen eines Beschlusses gezeichnet sein und können per Brief, Tele-
gramm, Fax oder E-Mail erfolgen.

Das Protokoll von Versammlungen der Geschäftsführer der Verwaltungsgesellschaft ist von dem Vorsitzenden oder,

sofern dieser abwesend ist, von dem stellvertretenden, nur für die jeweilige Versammlung ernannten Vorsitzenden oder
von zwei Geschäftsführern zu unterzeichnen.

Kopien von oder Auszüge aus solchen Protokollen, die gegebenenfalls in Gerichtsverfahren oder bei anderen Gele-

genheiten vorgelegt werden, sind von dem Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern oder von einem Geschäftsführer
gemeinsam mit dem Sekretär oder dem stellvertretenden Sekretär zu unterzeichnen.

Art. 11. Der Rat der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft ist befugt, die Richtung und Art der Geschäftsfüh-

rung und der Geschäfte der Verwaltungsgesellschaft festzulegen.

Der Rat der Geschäftsführung ist mit den größtmöglichen Befugnissen ausgestattet, um sämtliche im Interesse der

Verwaltungsgesellschaft  stehenden  Verwaltungshandlungen  und  -verfügungen  vorzunehmen.  Sämtliche  Befugnisse,  die
nicht kraft Gesetzes oder gemäß dieser Satzung ausdrücklich der jährlichen Gesellschafterversammlung zugewiesen sind,
werden vom Geschäftsführer, oder, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, vom Rat der Geschäftsführung der
Verwaltungsgesellschaft ausgeübt.

Art. 12. Die Verwaltungsgesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Geschäftsführern der Verwal-

tungsgesellschaft, oder durch die alleinige Unterschrift des Day-to-Day Managers oder eines Bevollmächtigten oder einer
Person oder mehrerer Personen, auf die ein solches Zeichnungsrecht durch den Rat der Geschäftsführung der Verwal-
tungsgesellschaft übertragen worden ist.

Art. 13. Der Rat der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft kann seine Befugnisse zur Führung der täglichen

Geschäfte der Verwaltungsgesellschaft, einschließlich des Rechts, für die Gesellschaft zu zeichnen, sowie seine Befugnisse,
Handlungen zur Förderung der Unternehmenspolitik und des Gesellschaftszwecks vorzunehmen, an Bevollmächtigte der
Verwaltungsgesellschaft oder andere Personen übertragen, die wiederum berechtigt sind, Untervollmachten zu erteilen,
sofern sie vom Rat der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft hierzu ermächtigt worden sind.

Art. 14. Verträge oder andere Transaktionen der Verwaltungsgesellschaft mit einer anderen Gesellschaft oder einem

anderen Unternehmen bleiben unberührt und werden nicht unwirksam, wenn ein oder mehrere der Geschäftsführer
oder Bevollmächtigte der Verwaltungsgesellschaft aufgrund persönlicher Beziehungen ein Interesse an dieser anderen
Gesellschaft oder diesem anderen Unternehmen hat oder haben oder dort Geschäftsführer oder Bevollmächtigter oder
Mitarbeiter ist oder sind, sofern sich die Verwaltungsgesellschaft verpflichtet, nicht wissentlich Vermögenswerte von
OGAs, die sie verwaltet, an ihre Geschäftsführer oder Bevollmächtigte oder von diesen beherrschte Gesellschaften oder
Unternehmen zu verkaufen oder zu verleihen.

Falls ein Geschäftsführer oder Bevollmächtigter der Verwaltungsgesellschaft möglicherweise aus anderen Gründen als

aufgrund des Umstands,  dass er Geschäftsführer,  Bevollmächtigte, Mitarbeiter oder  Inhaber  von  Wertpapieren  oder
sonstigen Beteiligungen des anderen Unternehmens ist, ein persönliches Interesse an einem Vertrag oder einer Trans-
aktion  der  Verwaltungsgesellschaft  hat,  wird  der  Rat  der  Geschäftsführung  der  Verwaltungsgesellschaft  von  diesem
persönlichen Interesse in Kenntnis setzen und von einer Beteiligung an Beschlussfassungen hinsichtlich eines solchen
Vertrags oder einer solchen Transaktion absehen. Die jeweils nächste Gesellschafterversammlung ist von einem solchen
Vertrag oder einer solchen Transaktion und dem persönlichen Interesse des betreffenden Geschäftsführers oder Bevoll-
mächtigten zu unterrichten.

Art. 15.  Die  Verwaltungsgesellschaft  kann  einen  Geschäftsführer  oder,  seine  Erben,  Testamentsvollstrecker  oder

Nachlassverwalter für angemessene Kosten schadlos halten, die diesem oder diesen in Zusammenhang mit einem An-
spruch, einer Klage oder einem Verfahren entstanden sind, die möglicherweise auf der jetzigen oder früheren Tätigkeit
des Betreffenden als Geschäftsführer oder Bevollmächtigte für die Verwaltungsgesellschaft oder für eine andere Gesell-
schaft beruhen, sofern dies verlangt wird, deren Anteilinhaber oder Gläubiger die Verwaltungsgesellschaft ist, wenn der
Betreffende insoweit keinen anderen Schadloshaltungsanspruch hat; dies gilt nicht, wenn der Geschäftsführer oder Be-
vollmächtigte wegen grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz rechtskräftig verurteilt wird; wird ein Vergleich geschlossen,
erfolgt die Schadloshaltung nur bezüglich solcher vom Vergleich erfassten Punkte, bezüglich derer- laut Auskunft des
Rechtsberaters gegenüber der Verwaltungsgesellschaft - keine Pflichtverletzung der schadlos zu haltenden Person vorliegt.
Das vorstehende Recht auf Schadloshaltung schließt andere, dem Geschäftsführer oder Bevollmächtigte möglicherweise
zustehende Rechte nicht aus.

Abschnitt V. Buchhaltung, Ausschüttung von Dividenden

Art. 16. Die Geschäfte der Verwaltungsgesellschaft, ihre finanzielle Situation sowie ihre Bücher werden von einem

(oder mehreren) Abschlussprüfer(n) überwacht, bei denen es sich um reviseur d'enterprises agréé(s) handelt. Der Ab-
schlussprüfer (oder die Abschlussprüfer) wird von den Gesellschaftern bei der jährlichen Gesellschafterversammlung für
einen Zeitraum bestimmt, der am Tage der nächsten jährlichen Gesellschafterversammlung endet, an dem über die Be-
stellung des Nachfolgers oder der Nachfolger entschieden wird.

102373

L

U X E M B O U R G

Art. 17. Das Geschäftsjahr der Verwaltungsgesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden

Jahres.

Art. 18. Von dem Jahresüberschuss der Verwaltungsgesellschaft werden fünf Prozent (5 %) in die gesetzlich vorge-

schriebenen Reserven eingestellt. Diese Zuführung von Geldern endet, sobald und solange die Reserven bei zehn Prozent
(10 %) des Kapitals der Verwaltungsgesellschaft gemäß Artikel 5 dieser Satzung oder dem gegebenenfalls gemäß Artikel
5 dieser Satzung herauf- oder herabgesetzten Betrag liegen.

Die Gesellschafterversammlung beschließt jährlich über die Verwendung des Jahresüberschusses; sie kann ggf. Divid-

enden festsetzen oder den Rat der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft anweisen, dies zu tun.

Der Rat der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft kann im gesetzlich vorgesehenen Rahmen einstimmig die

Ausschüttung von Interimdividenden beschließen.

Abschnitt VI. Auflösung, Liquidation

Art. 19. Im Falle einer Auflösung der Verwaltungsgesellschaft erfolgt die Liquidation durch einen oder mehrere Liqui-

datoren. Bei den Liquidatoren kann es sich um natürliche oder juristische Personen handeln, die von der Gesellschafter-
versammlung bestellt werden, die über die Auflösung entscheidet und die Befugnisse und die Vergütung der Liquidatoren
bestimmt.

Abschnitt VII. Änderungen

Art. 20. Diese Satzung kann im Rahmen einer Gesellschafterversammlung geändert werden, wenn diese beschlussfähig

ist und die nach luxemburgischen Recht erforderlichen Mehrheiten erreicht werden.

Art. 21. Alle Fragen, die nicht in dieser Satzung geregelt sind, sind gemäß dem Gesetz vom 10. August 1915 über die

Handelsgesellschaften in der jeweils geltenden Fassung und, insoweit anwendbar, dem Gesetz von 2010 und dem AIFM
Gesetz zu lösen.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2014.

<i>Zeichnung und Zahlung

Das Kapital der Gesellschaft wird folgendermaßen gezeichnet:
- Die oben genannte JAB Partners S.à r.l, zeichnet zweitausendsechshundertvierundvierzig (2,644) Gesellschaftsanteile

zu einem Nennbetrag von jeweils hundert Euro (EUR 100,-) gegen Zahlung von insgesamt zweihundertvierundsechzig-
tausendvierhundert Euro (EUR 264,400.-); und

- Der oben genannte Herr Philip von Wulfen, zeichnet einhundert und sechs (106) Gesellschaftsanteile zu einem

Nennbetrag von jeweils hundert Euro (EUR 100,-) gegen Zahlung von insgesamt zehntausendsechshundert Euro (EUR
10,600.-)

Der Nachweis über diese Zahlung wurde gegenüber dem unterzeichneten Notar erbracht.

<i>Kosten:

Die von der Verwaltungsgesellschaft infolge der Gründung der Gesellschaft zu tragenden Kosten belaufen sich auf zwei

tausend Euros.

<i>Gesellschafterversammlung

Als Inhaber des gesamten gezeichneten Kapitals der Gesellschaft fasst die oben genannten Parteien in Ausübung der

der Gesellschafterversammlung übertragenen Befugnisse die folgenden Beschlüsse:

(i) Die folgenden Personen werden bis zur Gesellschafterversammlung, welche den Jahresabschluss zum 31 Dezember

2014 behandelt, als Geschäftsführer bestellt:

- Herr Joachim Creus geschäftsansässig in 5, rue Goethe, L-1637 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
- Herr Markus Hopmann geschäftsansässig in Ludwig-Bertram-Strasse 8+10, 67059 Ludwigshafen, Deutschland;
- Herr David Bell geschäftsansässig in 2200 Pennsylvania Avenue, NW, Washington DC 20037, Vereinigte Staaten;
- Herr Philip von Wulffen geschäftsansässig in 5, rue Goethe, L-1637 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg; und
- Mr Axel Bhat, geschäftsansässig in at 2200 Pennsylvania Avenue, NW, Washington DC 20037, United States.
Als unabhängiger Abschlussprüfer wird für die Dauer eines Zeitraums bis zum Ende der jährlichen Gesellschafterver-

sammlung, die über den Jahresabschluss zum 31 Dezember 2014: KPMG Luxembourg S.à r.l., 9, Allée Scheffer, L-2520
Luxembourg. Grand Duchy of Luxembourg.

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 5, rue Goethe, L-1637 L-1637 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg.

Daraufhin wurde der vorstehende Akt in Luxemburg zu dem oben genannten Datum notariell beurkundet.

102374

L

U X E M B O U R G

Nachdem der Text dem Bevollmächtigten der Erschienenen vorgelesen wurde, dessen Vor- und Nachname, Status

und Wohnsitz dem Notar bekannt sind, wurde die vorliegende Urkunde im Original von dem Bevollmächtigten der
Erschienenen gemeinsam mit dem Notar unterzeichnet.

Der unterzeichnete Notar, der der englischen Sprache kundig ist, stellt hiermit fest, dass auf Verlangen der vorstehend

genannten Personen die vorliegende Urkunde in englischer Sprache abgefasst wurde, gefolgt von einer deutschen Fassung;
auf Wunsch der vorstehend genannten Personen ist bei Widersprüchen zwischen der englischen und der deutschen
Fassung die englische Fassung maßgeblich.

Signé: F. GIBERT, J. E LVINGER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils le 22 mai 2014. Relation: LAC/2014/23682. Reçu soixante quinze euros (EUR

75,-).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

Référence de publication: 2014083132/560.
(140097006) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2014.

Stabilus S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 151.589.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-seventh day of May.
Before us Maître Marc Loesch, notary, residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,

there appeared

Mr Emmanuel Lamaud, lawyer, professionally residing at 33, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
acting as the representative of the management board (the Management Board) of Stabilus S.A., a public limited liability

company (société anonyme), having its registered office at 2, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 151.589 (the Company),

pursuant to the resolutions of the Management Board passed at a meeting held on 22 May 2014 (the Capital Increase

Resolutions).

Evidence of the passing of the Capital Increase Resolutions has been provided to the undersigned notary who confirms

this.

The appearing person, representing the Management Board pursuant to the Capital Increase Resolutions, requested

the notary to record the following statements:

1. The Company was incorporated on 26 February 2010 pursuant to a notarial deed, published in the Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations - No. 731 of 8 April 2010. The articles of association of the Company have been
amended for the last time by a notarial deed dated 5 May 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations - No. 1250 of 16 May 2014.

2. Article 5.5 of the articles of association of the Company (the Articles) reads as follows:

“ 5.5. Authorisation for the Management Board to increase the share capital.
(a) Size of the authorisation
The authorised capital of the Company is set at EUR 315,000 (three hundred and fifteen thousand Euros) represented

by maximum of 31,500,000 (thirty-one million five hundred thousand) shares, each with a nominal value of EUR 0.01 (one
Cent).

(b) Terms of the authorisation
The Management Board is authorised, during a period starting on the date of the publication in the Luxembourg Official

Gazette (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations) of the General Meeting approving the authorisation of the
Management Board under this Article 5.5, and expiring on the fifth anniversary of such date (the Period), to increase the
current share capital up to the amount of the authorised capital, in whole or in part from time to time, (i) by way of
issuance of shares in consideration for a payment in cash, (ii) by way of issuance of shares in consideration for a payment
in kind and (iii) by way of capitalisation of distributable profits and reserves, including share premium and capital surplus,
with or without an issuance of new shares.

The Management Board is authorised to determine the terms and conditions attaching to any subscription and issuance

of shares pursuant to the authority granted under this Article 5.5, including by setting the time and place of the issue or
the successive issues of shares, the issue price, with or without a share premium, and the terms and conditions of payment
for the shares under any documents and agreements including, without limitation, convertible loans, option agreements
or stock option plans.

The Management Board is authorised to (i) during the Period, (a) issue convertible bonds, or any other convertible

debt instruments, bonds carrying subscription rights or any other instruments entitling their holders to subscribe for or
be allocated with shares, such as, without limitation, warrants (the Instruments), and (b) issue shares subject to and

102375

L

U X E M B O U R G

effective as of the exercise of the rights attached to the Instruments, until, with respect to both items (a) and (b), the
amount of increased share capital that would be reached as a result of the exercise of the rights attached to the Instruments
is  equal  to  the  authorised  share  capital,  and  (ii)  issue  shares  pursuant  to  the  exercise  of  the  rights  attached  to  the
Instruments until the amount of increased share capital resulting from such issuance of shares is equal to the authorised
share capital, at any time, whether or not during the Period; provided that the Instruments are issued during the Period.
The shares to be issued following the exercise of the rights attached to the Instruments may be carried out by a payment
in cash, a payment in kind or a capitalisation of distributable profits and reserves, including share premium and capital
surplus.

The Management Board is authorised to determine the terms and conditions of the Instruments, including the price,

the interest rate, the exercise rate, conversion rate or the exchange rate, and the repayment conditions, and to issue
such Instruments.

(c) Authorisation to cancel or limit the pre-emptive rights
The Management Board may, during the Period, cancel or limit the preemptive rights of the shareholders set out in

the Companies Act, as reflected in Article 5.3, in connection with an issue of new shares and Instruments under the
authorisation set out in this Article 5.5.

(d) Recording of capital increases in the Articles
Article 5 of the Articles shall be amended so as to reflect each increase in share capital pursuant to the use of the

authorisation granted to the Management Board under this Article 5 and the Management Board shall take or authorise
any person to take any necessary steps for the purpose of the recording of such increase and the consequential amend-
ments to the Articles before a notary.”

3. Pursuant to the Capital Increase Resolutions, the Management Board inter alia:
(a) approved, effective as of the payment of the Aggregate Issue Price as evidenced by the Bank Certificate (each as

defined below) and the receipt of the Subscription Certificate (as defined below), the increase, within the limits of the
authorized share capital, of the Company's share capital by an amount of EUR 30,232.56 (thirty thousand two hundred
and thirty-two Euro and fifty-six Cents) in order to bring the Company's share capital from its current amount of EUR
177,000 (one hundred and seventy-seven thousand Euro), represented by 17,700,000 (seventeen million seven hundred
thousand) shares in bearer form of the Company with a nominal value of EUR 0.01 (one Cent) each, to an amount of
EUR 207,232.56 (two hundred and seven thousand two hundred and thirty-two Euro and fifty-six Cents), by way of the
issuance of 3,023,256 (three million twenty-three thousand two hundred and fifty-six) new bearer shares of the Company
having a nominal value of EUR 0.01 (one Cent) each and a subscription price per share of EUR 21.50 (twenty-one Euro
and fifty Cents) (the New Shares);

(b) cancelled, for the purpose of the above mentioned share capital increase, the pre-emptive rights of the sole sha-

reholder of the Company in respect of the issue of the New Shares;

(c) accepted the subscription to the New Shares by Commerzbank Aktiengesellschaft by way of contribution in cash

in an aggregate amount of EUR 65,000,004 (sixty-five million and four Euro) in accordance with the terms of a subscription
certificate issued by Commerzbank Aktiengesellschaft and countersigned by the Company (the Subscription Certificate);

(d) noted that proper evidence of the payment of the aggregate issue price for the New Shares, representing EUR

65,000,004 (sixty-five million and four Euro) (the Aggregate Issue Price) by Commerzbank Aktiengesellschaft on the
Company's bank account as evidenced by a bank certificate addressed to a Luxembourg notary (the Bank Certificate)
was to be given to the Management Board prior to or at the time of the issuance of the New Shares;

(e) resolved that the total amount of EUR 65,000,004 (sixty-five million and four Euro) to be paid for the New Shares

will be allocated as follows: EUR 30,232.56 (thirty thousand two hundred and thirty-two Euro and fifty-six Cents) to the
nominal share capital account of the Company and EUR 64,969,771.44 (sixty-four million nine hundred and sixty-nine
thousand seven hundred and seventy-one Euro and forty-four Cents) to the share premium account of the Company;

(f) resolved that, once effective, the share capital increase shall be recorded by way of a notarial deed at which occasion,

inter alia, proper evidence of the payment of the Aggregate Issue Price be given to the Luxembourg public notary which
shows that the Aggregate Issue Price is available to the Company (in the form of the Bank Certificate) so as to allow the
Luxembourg public notary to record that the New Shares issued to Commerzbank Aktiengesellschaft are fully paid-up
by payment in cash to the Company; and

(g) resolved to give full power of substitution, to, inter alia, any lawyer of Allen &amp; Overy, a société en commandite

simple, each acting individually, to appear before a notary public in Luxembourg to register the share capital increase
decided under the Capital Increase Resolutions and record the subscription and payment of the New Shares by way of
contribution in cash, to amend the Articles accordingly and to do any and all things which may be necessary or useful in
connection therewith.

4. Evidence of the passing of the resolutions of the Management Board on 22 May 2014 has been given to the notary

who confirms this.

5. The New Shares have been subscribed and fully paid by Commerzbank Aktiengesellschaft for the number of New

Shares and the Aggregate Issue Price; evidence of which has been provided to the notary who confirm this.

102376

L

U X E M B O U R G

6. The amount of EUR 65,000,004 (sixty-five million and four Euro), representing the Aggregate Issue Price, is therefore

at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the notary who confirms this.

7. The issuance of the New Shares to Commerzbank Aktiengesellschaft and the share capital increase of the Company,

as described above, is effective and, consequently, article 5.1 of the Articles is amended so as to read as follows:

“ 5.1. Outstanding share capital. The share capital is set at EUR 207,232.56 (two hundred and seven thousand two

hundred and thirty-two Euro and fifty-six Cents) represented by 20,723,256 (twenty million seven hundred and twenty-
three thousand two hundred and fifty-six) shares having a nominal value of EUR 0.01 (one Cent) each.”

<i>Costs

The expenses, costs, remuneration and charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately six thousand five hundred euro (EUR 6,500).

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the deed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing person

the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person and in case
of divergences between the English text and the French text, the English text will prevail.

After reading the present deed to the appearing person, known to the notary by his name, first name, civil status and

residence, the said appearing person signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le vingt-septième jour du mois de mai,
par devant Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU

Monsieur Emmanuel Lamaud, avocat, demeurant professionnellement au 33, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
agissant comme représentant du directoire (le Directoire) de Stabilus S.A., une société anonyme de droit luxembour-

geois ayant son siège social au 2, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 151.589 (la Société),

conformément aux résolutions du Directoire datées du 22 mai 2014 (les Résolutions d’Augmentation de Capital).
Preuve de la prise des Résolutions d’Augmentation de Capital a été donnée au notaire instrumentaire qui le confirme

expressément.

La partie comparante, représentant le Directoire selon les Résolutions d’Augmentation de Capital, a requis le notaire

instrumentaire d’enregistrer les déclarations suivantes:

(1) La Société a été constituée le 26 février 2010 par un acte notarié, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et

Association n° 731 du 8 avril 2010. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois le 5 mai 2014 en vertu
d’un acte notarié, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations - N° 1250 du 16 mai 2014.

(2) L’article 5.5 des statuts de la Société (les Statuts) a la teneur suivante:

« 5.5. Autorisation pour le Directoire d’augmenter le capital.
(a) Montant de l’autorisation
Le capital autorisé de la Société est fixé à un montant de EUR 315.000 (trois cent quinze mille euros) représenté par

un maximum de 31.500.000 (trente-et-un millions cinq cent mille) actions, ayant une valeur nominale de EUR 0,01 (un
centime d’euro) chacune.

(b) Conditions de l’autorisation
Le Directoire est autorisé à augmenter le capital social existant jusqu’au montant de capital autorisé, en une ou plusieurs

fois, au cours d’une période débutant à la date de publication au Journal Officiel de Luxembourg (Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations) de l’Assemblée Générale approuvant l’autorisation donnée au Directoire par cet Article
5.5, et se terminant au cinquième anniversaire de cette date (la Période) au moyen de (i) l’émission d’actions en raison
d’apports en numéraire, (ii) l’émission d’actions en raison d’apports en nature, et (iii) l’incorporation des bénéfices et
réserves distribuables, y inclus la prime d’émission et le capital surplus, avec ou sans émission de nouvelles actions.

Le Directoire est autorisé à définir les conditions applicables à toute souscription et émission d’actions conformément

au pouvoir qui lui est conféré aux termes de cet Article 5.5, et notamment de déterminer le lieu et la date de l’émission
ou des émissions successives d’actions, le prix d’émission, l’existence ou non d’une prime d’émission, ainsi que les mo-
dalités de paiement des actions en vertu de tout document ou contrat y compris et de manière non exhaustive un prêt
convertible, un contrat d’option ou un plan d’options sur actions.

Le Directoire est autorisé (i) durant la Période, (a) à émettre des obligations convertibles ou tous autres instruments

de dette convertibles, des obligations assorties d’un droit de souscription et autres instruments permettant à leur dé-
tenteur de souscrire à des actions ou de se voir attribuer des actions, tels que (liste non exhaustive) des warrants (les
Instruments), et (b) à émettre des actions sous la condition de l’exercice des droits attachés aux Instruments et dont
l’émission est effective à compter de cet exercice jusqu’à ce que, en ce qui concerne chacun des points (a) et (b), le

102377

L

U X E M B O U R G

montant du capital social augmenté atteint en conséquence de l’exercice des droits attachés aux Instruments soit égal au
capital autorisé, et (ii) à émettre des actions en raison de l’exercice des droits attachés aux Instruments jusqu’à ce que
le montant du capital social augmenté atteint en conséquence d’une telle émission d’actions soit égal au capital autorisé,
à tout moment, que ce soit pendant la Période ou en dehors de la Période, à la condition que les Instruments soient émis
pendant la Période. Les actions devant être émises en conséquence de l’exercice des droits attachés aux Instruments
peuvent être payées par un apport en numéraire, un apport en nature, ou au moyen de l’incorporation de bénéfices et
de réserves distribuables, en ce compris la prime d’émission et le capital surplus.

Le Directoire est autorisé à déterminer les conditions applicables aux Instruments, y compris le prix, le taux d’intérêt,

le prix d’exercice, le taux de conversion ou le taux de change, ainsi que les modalités de remboursement, et à émettre
lesdits instruments.

(c) Autorisation de supprimer ou de limiter les droits préférentiels de souscription
Le Directoire peut (i) supprimer ou limiter les droits préférentiels de souscription des actionnaires prévus par la Loi

de 1915, tels que reflétés dans l’Article 5.3, portant sur l’émission de nouvelles actions et d’Instruments.

(d) Modification des Statuts consécutive à une augmentation de capital
L’Article 5 des présents Statuts sera modifié de façon à refléter chaque augmentation du capital effectuée en vertu de

l’autorisation accordée au Directoire conformément à l’Article 5, et le Directoire prendra lui-même ou autorisera toute
personne à prendre toutes les mesures nécessaires afin de faire constater par-devant notaire l’augmentation de capital
social et les modifications consécutives des Statuts.»

(3) Conformément aux Résolutions d’Augmentation de Capital, le Directoire, inter alia:
(a) approuva, avec effet au paiement du Montant d’Emission Total tel que démontré par le Certificat Bancaire (chacun

tel que défini ci-après) et la réception du Certificat de Souscription (tel que défini ci-après), l’augmentation, dans les limites
du capital autorisé, du capital social de la Société d’un montant de 30.232,56 EUR (trente mille deux cent trente-deux
euros et cinquante-six centimes), de façon à faire passer le capital social de la Société d’un montant de 177.000 EUR (cent
soixante-dix-sept mille euros), représenté par 17,700,000 (dix-sept millions sept cent mille) actions au porteur ayant une
valeur nominale de 0,01 EUR (un centime d’euro) chacune, à un montant de 207.232,56 EUR (deux cent sept mille deux
cent trente-deux euros et cinquante-six centimes), par la création et l’émission de 3.023.256 (trois millions vingt-trois
mille deux cent cinquante-six) nouvelles actions au porteur de la Société, ayant chacune une valeur nominale de 0,01 EUR
(un centime d’euro), et un prix de souscription par action de 21,50 EUR (vingt-et-un euros et cinquante centimes) (les
Nouvelles Actions);

(b) annula, pour les besoins de l’augmentation de capital mentionnée ci-dessus, les droits préférentiels de souscription

de l’actionnaire unique à l’égard des Nouvelles Actions;

(c) accepta la souscription aux Nouvelles Actions par Commerzbank Aktiengesellschaft, au moyen d’un versement en

numéraire d’un montant total de 65.000.004 EUR (soixante-cinq millions et quatre euros) conformément aux termes du
certificat de souscription émis par Commerzbank Aktiengesellschaft et contresigné par la Société (le Certificat de Sou-
scription);

(d)  pris  acte  que  la  preuve  de  paiement  du  montant  d’émission  total  pour  les  Nouvelles  Actions,  représentant

65.000.004 EUR (soixante-cinq millions et quatre euros) (le Montant d’Emission Total) par Commerzbank Aktiengesell-
schaft sur le compte bancaire de la Société, tel que documenté par le certificat bancaire adressé à un notaire à Luxembourg
(le Certificat Bancaire) a été donné au Directoire avant ou au moment de l’émission des Nouvelles Actions;

(e) décida que le montant total de 65.000.004 EUR (soixante-cinq millions et quatre euros) à payer pour les Nouvelles

Actions sera alloué comme suit: 30.232,56 EUR (trente mille deux cent trente-deux euros et cinquante-six centimes) au
compte capital social nominal de la Société et 64.969.771,44 EUR (soixante-quatre millions neuf cent soixante-neuf mille
sept cent soixante-et-onze euros et quarante-quatre centimes) au compte prime d’émission de la Société;

(f) décida que, une fois en vigueur, l’augmentation de capital doit être enregistrée par un acte notarié à l’occasion de

laquelle, inter alia, une preuve de paiement du Montant Total d’Emission sera donnée au notaire montrant que le Montant
Total d’Emission est à la disposition de la Société (sous la forme du Certificat Bancaire) de manière à permettre au notaire
d’enregistrer que les Nouvelles Actions émises à Commerzbank Aktiengesellschaft sont entièrement libérées par apport
en numéraire à la Société; et

(g) décida d’accorder pouvoir de substitution, inter alia, à tout avocat ou employé d’Allen &amp; Overy, société en com-

mandite simple, agissant individuellement, pour se présenter devant un notaire à Luxembourg afin d’acter l’augmentation
de capital de la Société ainsi décidée par les Résolutions d’Augmentation de Capital et d’acter la souscription et le paiement
des Nouvelles Actions par apport en numéraire, de modifier les Statuts en conséquence et de prendre toutes les mesures
jugées nécessaires et appropriées dans le cadre de cette augmentation de capital.

(4) Une preuve de l’adoption des résolutions du Directoire datées du 22 mai 2014 a été présentée au notaire qui le

confirme expressément.

(5) Les Nouvelles Actions ont été souscrites et entièrement payées par Commerzbank Aktiengesellschaft pour le

nombre de Nouvelles Actions et le Montant Total d’Emission, preuve en a été donnée au notaire instrumentaire qui le
confirme expressément.

102378

L

U X E M B O U R G

(6) Le montant de 65.000.004 EUR (soixante-cinq millions et quatre euros), représentant le Montant Total d’Emission,

est à la disposition de la Société, ainsi qu’il en a été attesté au notaire instrumentaire, qui le confirme expressément.

(7) L’émission des Nouvelles Actions à Commerzbank Aktiengesellschaft et l’augmentation de capital de la Société,

telle que décrite ci-dessus, est effective et l’article 5.1 des Statuts est modifié par conséquent comme suit:

« 5.1 Montant du capital social. Le capital social est fixé à un montant de EUR 207.232,56 (deux cent sept mille deux

cent trente-deux euros et cinquante-six centimes), représenté par 20.723.256 (vingt millions sept cent vingt-trois mille
deux cent cinquante-six) actions ayant une valeur nominale de EUR 0.01 (un centime d’euro) chacune.»

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte sont

estimés à environ six mille cinq cents euros (EUR 6.500).

Le notaire soussigné, qui parle et comprend l’anglais, déclare que le comparant l’a requis de documenter le présent

acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le
texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant qui est connu du notaire instrumentant par ses nom,

prénom, état et demeure, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: E. Lamaud, M. Loesch.
Enregistré à Remich, le 3 juin 2014. REM/2014/1194. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): P. MOLLING.

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 16 juin 2014.

Référence de publication: 2014084101/238.
(140099246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2014.

Bautra S.A., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9053 Ettelbruck, 45, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 187.756.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendvierzehn, am zehnten Juni.
Vor dem unterzeichneten Notar Pierre PROBST, mit dem Amtssitz in Ettelbruck;

Sind erschienen:

1) Herr Michael FEIT, staatlich geprüfter Techniker, geboren am 14/06/1966 in Dierfeld (D), wohnhaft in D-54338

Schweich, Oberstiftstr. 32;

2) Herr Johann FEIT, Bilanzbuchhalter, geboren am 31/03/1965 in Dierfeld (D), wohnhaft in D-54533 Oberöfflingen,

Im Kirchgarten 7;

3) Herr Mario KNAUF, Diplom-Ingenieur, geboren am 19/10/1974 in Prüm (D), wohnhaft in D-54675 Körperich,

Bergstr. 12a;

4) Herr Heiko KRASSER, Diplom-Ingenieur, geboren am 2/01/1976 in Gerolstein (D), wohnhaft in D-54552 Schal-

kenmehren, Weinbachstr. 13

Die Erschienenen, handelnd wie angegeben, haben den unterzeichnenden Notar ersucht, folgendes zu aktieren und

die Gründung einer Aktiengesellschaft urkundlich festzustellen deren Satzung wie folgt lautet:

A. Zweck - Dauer - Name - Sitz

Art. 1. Es besteht eine Aktiengesellschaft („société anonyme“) nach luxemburgischem Recht mit dem Firmennamen

„BAUTRA S.A.“ (nachstehend die „Gesellschaft“), welche den Bestimmungen des Gesetzes über Handelsgesellschaften
vom 10. August 1915 in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und den Bestimmungen der vorliegende Satzung
unterliegt.

Art. 2. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet.

Art. 3. Unternehmensgegenstand der Gesellschaft ist das Engineering für den Wohnungs- und Gewerbebau, die Ers-

tellung von Entwurfs-, Tragwerks- und Ausführungsplanung, Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung von Bauleistungen,
Bauleitung und Dokumentation.

Die Gesellschaft kann sämtliche Operationen vornehmen, welche direkt oder indirekt mit dem Hauptzweck in Zu-

sammenhang stehen oder zur Erreichung und Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft dienlich sein können.. Die

102379

L

U X E M B O U R G

Gesellschaft kann sich gleichfalls durch Einbringungen, Anteilzeichnungen Verschmelzungen oder auf jeder Art und Weise
an allen anderen Gesellschaften und Unternehmen beteiligen, die einen gleichen oder ähnlichen Zweck verfolgen, oder
die Ausdehnung und Entwicklung der hiermit gegründeten Gesellschaft begünstigen könnten.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Wasserbillig, Großherzogtum Luxemburg. Der Ge-

sellschaftssitz kann durch einen Beschluss des Verwaltungsrates oder des alleinigen Verwaltungsratsmitgliedes an jeden
beliebigen Ort in derselben Gemeinde verlegt werden.

Die  Gesellschaft  kann  durch  einen  Beschluss  des  Verwaltungsrates  oder  des  alleinigen  Verwaltungsratsmitgliedes

Zweigstellen oder Agenturen sowohl in Luxemburg als auch im Ausland errichten.

Sollte  der  Verwaltungsrat  oder  das  alleinige  Verwaltungsratsmitglied  feststellen,  dass  außerordentliche  politische,

wirtschaftliche oder gesellschaftliche Entwicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhn-
lichen Tätigkeiten der Gesellschaft an ihrem Gesellschaftssitz oder die Kommunikation zwischen ihrem Gesellschaftssitz
und Personen im Ausland stören können, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend ins Ausland verlegt werden, bis
zur vollständigen Normalisierung der Verhältnisse; solche vorübergehenden Maßnahmen haben keinen Einfluss auf die
Nationalität der Gesellschaft, welche trotz einer vorübergehenden Verlegung ihres Gesellschaftssitzes eine luxemburgi-
sche Gesellschaft bleibt.

B. Gesellschaftskapital - Aktien

Art. 5. Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt sechsunddreissigtausend Euro (EUR 36.000.-). Es ist in dreihun-

dertsechzig (360) Aktien zu hundert Euro (100.-€) Nennwert eingeteilt und in voller Höhe einbezahlt

Durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre oder des alleinigen Aktieninhabers, welcher in gleicher

Weise wie für Satzungsänderungen erforderlich getroffen werden muss, kann das gezeichnete und genehmigte Kapital
der Gesellschaft erhöht oder reduziert werden. Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes von 1915 und nach den
darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien erwerben.

Art. 6. Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Aktionäre haben. Die Gesellschaft wird weder durch Tod, noch

durch Entmündigung, Insolvenz oder Zahlungsunfähigkeit ihrer Aktionäre (oder eines Aktionärs) aufgelöst.

Art. 7. Die Gesellschaftsaktien sind Namensaktien oder Inhaberaktien je nach Wahl des Besitzers..
Ein Register der Namensaktien wird am Gesellschaftssitz geführt, wo es jedem Aktionär zur Einsicht zur Verfügung

steht. Dieses Register enthält alle durch Artikel 39 des Gesetzes von 1915 vorgeschriebenen Auskünfte. Der Nachweis
des Eigentums an den Namensaktien kann aufgrund der Eintragung eines Aktionärs im Aktienregister erbracht werden.
Auf Ersuchen und auf Kosten eines Aktionärs werden Zertifikate dieser Eintragungen von zwei Verwaltungsratmitgliedern
oder dem alleinigen Verwaltungsratsmitglied ausgegeben und unterzeichnet.

Die Gesellschaft erkennt nur einen Inhaber pro Aktie an. Sollte das Eigentum an einer Aktie aufgeteilt sein, müssen

diejenigen, die ein Recht an dieser Aktie geltend machen, einen gemeinsamen Bevollmächtigten ernennen, der sie gege-
nüber der Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft kann die Ausübung aller Rechte bezüglich einer solchen Aktie aussetzen,
solange nicht eine einzelne Person zum gemeinsamen Bevollmächtigten gegenüber der Gesellschaft benannt worden ist.

C. Hauptversammlung der Aktionäre - Beschlüsse des Alleinigen Aktionärs

Art. 8. Auf der rechtmäßig einberufenen Hauptversammlung der Aktionäre werden alle Aktionäre vertreten. Sie hat

die weitestgehenden Befugnisse zur Anordnung, Ausführung oder Ratifizierung aller Handlungen im Hinblick auf die Ge-
schäfte der Gesellschaft.

Im Fall eines alleinigen Aktionärs übt dieser die Befugnisse der Hauptversammlung der Aktionäre aus und handelt

entsprechend. Von allen Beschlüsse des alleinigen Aktionärs wird schriftlicher Nachweis erbracht.

Die Hauptversammlung wird durch den Verwaltungsrat einberufen. Sie kann auch auf Antrag von Aktionären, welche

wenigstens zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals vertreten, einberufen werden. Ferner dürfen Aktionäre, die
wenigstens 10% des Gesellschaftskapitals halten, die Aufnahme eines oder mehrerer Punkte auf die Tagesordnung der
Hauptversammlung der Aktionäre verlangen. Dieser Antrag muss fünf (5) Tage vor dem festgesetzten Termin für die
Hauptversammlung am Gesellschaftssitz per Einschreiben gestellt werden.

Art. 9. Die jährliche Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft in Wasserbillig oder an einem anderen, in der

Einladung bestimmten Ort innerhalb der Gemeinde Luxemburgs jeweils am 2. Mittwoch im Monat Mai um 15:00 Uhr
jeden Jahres, statt. Andere Hauptversammlungen können an den in den Einberufungsschreiben bestimmten Zeitpunkten
und Orten einberufen werden.

Für Einberufungsschreiben und die Durchführung der Hauptversammlungen der Aktionäre der Gesellschaft gelten die

gesetzlichen Bestimmungen bezüglich Fristen und Anwesenheitsquoren, soweit diese Satzung keine anderweitigen Bes-
timmungen enthält.

Aktionäre, die an der Hauptversammlung per Telefonkonferenz, Videokonferenzschaltung oder durch ein vergleich-

bares  Kommunikationsmittel  teilnehmen,  sofern  diese  Kommunikationsmittel  ihre  Identifizierung  erlauben,  gelten  als
anwesend bei dieser Hauptversammlung für die Berechnung des Anwesenheitsquorums und der Mehrheiten. Das ver-

102380

L

U X E M B O U R G

wendete Kommunikationsmittel muss gewährleisten, dass die teilnehmenden Personen einander verstehen können, und
eine ununterbrochene, effektive Teilnahme an der Hauptversammlung erlauben.

Jede Aktie gewährt eine Stimme. Jeder Aktionär kann sich auf der Hauptversammlung durch einen schriftlich, per

Faxübertragung, E-Mail, Telegram oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel bevollmächtigten Dritten ver-
treten lassen.

Jeder Aktionär ist ermächtigt, mittels eines Stimmzettels, der per Post oder per Fax an den Gesellschaftssitz oder an

die im Einberufungsschreiben angegebene Adresse gesendet wird, an der Wahl teilzunehmen. Die Aktionäre dürfen nur
die  von  der  Gesellschaft  ausgegebene  Stimmzettel  verwenden,  auf  denen  zumindest  Ort,  Datum  und  Zeitpunkt,  die
Tagesordnung der Hauptversammlung, die zur Entscheidung der Hauptversammlung stehenden Anträge sowie für jeden
Antrag, drei Kästchen, die dem Aktionär, durch Ankreuzen des entsprechenden Kästchens erlauben, dem Antrag zuzus-
timmen, ihn abzulehnen oder sich zu enthalten, enthalten sind.

Stimmzettel,  die  nicht  ausschließlich  eine  Ja-  oder  Neinstimme  oder  eine  Enthaltung  aufweisen,  sind  ungültig.  Die

Gesellschaft berücksichtigt nur Stimmzettel, die vor dem Termin der entsprechenden Hauptversammlung eingegangen
sind.

Sofern nicht gesetzlich oder in dieser Satzung anders bestimmt werden Beschlüsse einer ordnungsgemäß einberufenen

Hauptversammlung mit Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Stimmen gefasst.

Der Verwaltungsrat kann weiteren Bedingungen für die Teilnahme der Aktionäre an einer Hauptversammlung festle-

gen.

Sind alle Aktionäre in einer Hauptversammlung anwesend oder vertreten und erklären sie, die Tagesordnung zu ken-

nen, so kann die Hauptversammlung ohne vorherige Einberufung abgehalten werden.

D. Verwaltungsrat

Art. 10. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat geführt, welcher aus mindestens drei Verwaltungsratmit-

gliedern bestehen muss, die nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen.

Die Verwaltungsratmitglieder können in A und B Mitglieder eingestuft werden
Für den Fall, dass die Gesellschaft von nur einem Aktionär gegründet wurde oder in einer Hauptversammlung fest-

gestellt  wird,  dass  alle  von  der  Gesellschaft  ausgegebenen  Aktien  von  einem  Aktionär  gehalten  werden,  kann  die
Gesellschaft durch ein alleiniges Verwaltungsratsmitglied geführt werden bis zu der nächsten Hauptversammlung der
Aktionäre nachdem die Gesellschaft festgestellt hat, dass ihre Aktien von mehr als einem Aktionär gehalten werden. Die
Mitglieder des Verwaltungsrates oder das alleinige Verwaltungsratsmitglied werden von der Hauptversammlung der Ak-
tionäre  oder  dem  alleinigen  Aktionär  gewählt;  ihre  Anzahl,  Bezüge  und  die  Dauer  ihres  Mandates  werden  von  der
Hauptversammlung festgesetzt. Die Mitglieder des Verwaltungsrats oder das alleinige Verwaltungsratsmitglied werden
für die Dauer eines Mandates gewählt, welches sechs Jahre nicht überschreiten darf und welches grundsätzlich mit der
Bestellung eines Nachfolgers endet.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates oder das alleinige Verwaltungsratsmitglied werden durch Beschluss der Aktionäre

mit einfacher Stimmenmehrheit gewählt.

Die Hauptversammlung der Aktionäre kann zu jeder Zeit und ohne Angabe von Gründen ein Mitglied des Verwal-

tungsrates abberufen. Mitglieder des Verwaltungsrates oder das alleinige Verwaltungsratsmitglied können wieder gewählt
werden.

Ist eine juristische Person als Verwaltungsratmitglieds bestimmt, muss sie einen ständigen Vertreter ernennen, der

diese Aufgabe im Namen und im Auftrag der juristischen Person ausführt. Diese juristische Person kann ihren Vertreter
nur abrufen, wenn sie gleichzeitig seinen Nachfolger ernennt.

Wird die Position des Verwaltungsrates durch Tod, Rücktritt oder aus einem sonstigen Grund frei, so kann das frei-

gewordene Amt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen vorläufig bis zur nächsten Hauptversammlung besetzt werden.

Art. 11. Der Verwaltungsrat wählt aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und hat die Möglichkeit, einen

stellvertretenden Vorsitzenden zu bestellen. Er kann außerdem einen Sekretär bestellen, welcher nicht Mitglied des Ver-
waltungsrates sein muss, und welcher für die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates und der Hauptversammlung
der Aktionäre, oder der Beschlüsse des alleinigen Aktionärs verantwortlich ist.

Die Versammlungen des Verwaltungsrates werden am Sitz der Gesellschaft gehalten, soweit nicht anders im Einberu-

fungsschreiben mitgeteilt. Der Verwaltungsrat wird durch den Vorsitzenden oder zwei seiner Mitglieder, an dem in dem
Einberufungsschreiben bestimmten Ort einberufen.

Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Sitzung des Verwaltungsrates; in seiner Abwesenheit kann der Verwaltungsrat

mit Zustimmung der Mehrheit der Anwesenden ein anderes Mitglied des Verwaltungsrates als Vorsitzenden auf Zeit
ernennen.

Außer in dringenden Fällen, wobei die Art und die Gründe dieser Dringlichkeit im Einberufungsschreiben angegeben

werden müssen, erhält jedes Mitglied des Verwaltungsrates wenigstens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem vorgese-
henen Zeitpunkt der Sitzung ein schriftliches Einberufungsschreiben. Auf das Einberufungsschreiben kann schriftlich, durch
Fax, E-Mail, Telegram oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel verzichtet werden. Für Sitzungen des Ver-

102381

L

U X E M B O U R G

waltungsrates,  die  zu  einer  Zeit  und  an  einem  Ort  abgehalten  werden,  welche  von  einem  vorherigen  Beschluss  des
Verwaltungsrates festgesetzt wurden, ist ein spezielles Einberufungsschreiben nicht erforderlich.

Sind alle Mitglieder des Verwaltungsrates in einer Sitzung anwesend oder vertreten oder im Falle schriftlicher Bes-

chlüsse, denen alle Verwaltungsratmitglieder zustimmen und die von allen Verwaltungsratsmitgliedern unterschrieben
werden, ist keine vorherige Einberufung erforderlich.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich in der Sitzung des Verwaltungsrates aufgrund einer schriftlich, durch Faxü-

bertragung, E-Mail, Telegram oder durch andere ähnliche Kommunikationsmittel erteilten Vollmacht durch ein anderes
Mitglied des Verwaltungsrates vertreten lassen. Ein Verwaltungsratsmitglied kann mehrere andere Verwaltungsratsmit-
glieder vertreten.

Jedes  Verwaltungsratsmitglied  kann  durch  Telefon-  oder  Videokonferenzschaltung  oder  durch  ein  vergleichbares

Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, vorausgesetzt, dass die Teilnehmer ständig einander hören können
und es eine effektive Teilnahme aller Teilnehmer an der Sitzung erlaubt. Die Teilnahme an einer Sitzung in dieser Weise
entspricht einer persönlichen Teilnahme.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.

Falls die Mitglieder in A und B Mitglieder eingestuft wurden, muss mindestens ein A und ein B Mitglied anwesend oder
vertreten sein damit der Verwaltungsrat beschlussfähig ist.

Gefasste Beschlüsse werden wirksam mit einfacher Mehrheit der auf der jeweiligen Sitzung anwesenden oder vertre-

tenen Mitglieder des Verwaltungsrates. Falls die Mitglieder in A und B Mitglieder eingestuft wurden, muss mindestens ein
A und ein B Mitglied für den Beschluss stimmen damit dieser wirksam wird.

Einstimmige Beschlüsse des Verwaltungsrates können auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrerer schrift-

licher, durch Faxübertragung, E-Mail, Telegram oder durch vergleichbare Kommunikationsmittel ausgedrückten Zustim-
mung gefasst werden. Die Gesamtheit der Unterlagen erbringt als Protokoll den Nachweis der Beschlussfassung.

Art. 12. Die Protokolle aller Sitzungen des Verwaltungsrates werden vom Vorsitzenden oder in seiner Abwesenheit

vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei (2) Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet. Die Kopien oder Aus-
züge der Protokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden, werden vom Vorsitzenden oder von zwei (2)
Verwaltungsratmitgliedern unterzeichnet.

Art. 13. Der Verwaltungsrat oder das alleinige Verwaltungsratsmitglied ist befugt, die Gesellschaft im weitesten Sinne

zu leiten und alle Verwaltungs- und Verfügungshandlungen vorzunehmen, welche im Interesse der Gesellschaft sind. Der
Verwaltungsrat oder das alleinige Verwaltungsratsmitglied hat sämtliche Befugnisse, welche durch das Gesetz oder durch
diese Satzung nicht ausdrücklich der Hauptversammlung vorbehalten sind.

Die laufende Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die diesbezügliche Vertretung Dritten gegenüber können gemäß

Artikel sechzig (60) des Gesetzes von 1915 auf ein oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsrates, leitende Angestellte,
Geschäftsführer oder sonstige Vertretungsberechtigte, welche nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen, und welche
gesamt- oder alleinzeichnungsberechtigt sein können, übertragen werden. Ihre Ernennung, Abberufung und sonstigen
Befugnisse werden durch Beschluss des Verwaltungsrates geregelt.

Ferner kann die Gesellschaft einzelne Aufgaben der Geschäftsführung durch privatschriftliche oder beglaubigte Voll-

macht übertragen.

Art. 14. Die Gesellschaft verpflichtet sich durch die Unterschrift des alleinigen Verwaltungsratsmitgliedes oder im Falle

von mehreren Verwaltungsratsmitgliedern durch die Unterschrift zweier Verwaltungsratsmitglieder, oder im Falle einer
Bevollmächtigung durch die Unterschrift jeder vom alleinigen Verwaltungsratsmitglied bzw. vom Verwaltungsrat bevoll-
mächtigten Person(en) im Rahmen der erteilten Unterschriftsbefugnis. Wurden die Verwaltungsratsmitglieder in A und
B Mitglieder eingestuft wird die Gesellschaft nur durch die gemeinsame Unterschrift eines A und B Mitglieds oder einer
bevollmächtigten Person verpflichtet.

E. Überwachung der Gesellschaft

Art. 15. Die Gesellschaft unterliegt der Überwachung durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer, die nicht Aktionäre

der Gesellschaft sein müssen. Die Hauptversammlung ernennt diese Rechnungsprüfer, bestimmt ihre Zahl und setzt ihre
Vergütung und die Dauer ihres Mandates, die sechs Jahre nicht überschreiten darf, fest. Die Rechnungsprüfer können
mehrmals hintereinander ernannt werden.

Die Funktion des Rechnungsprüfers wird abgeschafft und ein oder mehrere unabhängige Rechnungsprüfer werden aus

den Mitgliedern des institut des réviseurs d’entreprises durch die Hauptversammlung gewählt, die auch die Dauer ihres
Amtes bestimmt, wenn auf die Gesellschaft die Voraussetzungen des Artikels 35 für die in Artikel 36 des Gesetzes vom
19. Dezember 2002 über das Handels- und Gesellschaftsregister und die Buchführung und Bilanzierung von Gesellschaften
bestimmte Dauer zutreffen.

F. Geschäftsjahr - Bilanz

Art. 16. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember des gleichen Jahres.

102382

L

U X E M B O U R G

Art. 17. Es werden jährlich wenigstens fünf Prozent (5%) des möglichen Reingewinnes der Gesellschaft vorab den

gesetzlichen Rücklagen zugeführt bis diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals betragen.

Die Hauptversammlung oder der alleinige Aktionär bestimmt auf Vorschlag des Verwaltungsrates über die Verwendung

des restlichen Betrages des Reingewinns. Der Verwaltungsrat kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen Vor-
schussdividenden ausschütten.

G. Auflösung der Gesellschaft

Art. 18. Wird die Gesellschaft durch Beschluss der Hauptversammlung aufgelöst, so wird die Liquidierung durch einen

oder mehrere Abwickler, welche natürliche oder juristische Personen sein können, durchgeführt. Die Hauptversammlung
ernennt diese Abwickler und setzt ihre Befugnisse und Vergütung fest. Bei Fehlen ausdrücklicher anderweitiger Bestim-
mungen haben die Abwickler die größtmöglichen Befugnisse zur Verwertung der Vermögenswerte und zur Berichtigung
der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Der verbleibende Restbetrag wird zu gleichen Teilen unter den Aktionären verteilt.

H. Satzungsänderung

Art. 19. Die gegenwärtige Satzung kann durch Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre, unter Beachtung der

Anwesenheitsquoren gemäß Artikel 67-1 des Gesetzes von 1915 geändert werden.

I. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht

Art. 20. Für sämtliche Fragen, welche nicht durch diese Satzung geregelt sind, gilt das Gesetz von 1915 aus Luxemburg.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2014.

<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Die Aktien wurden wie folgt gezeichnet:

Herr Michael FEIT, vorbenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

181

Herr Johann FEIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107

Herr Mario KNAUF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36

Herr Heiko KRASSER, vorbenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 Aktien

Sämtliche Aktien wurden in voller Höhe einbezahlt, dem gemäß verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt

über den Betrag von sechsunddreißigtausend Euro (36.000 €) wie dem Notar nachgewiesen und diesem ausdrücklich
bestätigt wurde.

<i>Bescheinigung

Der unterzeichnende Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes von 1915 erfüllt sind.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Die der Gesellschaft aufgrund ihrer Gründung entstandenen Kosten, Gebühren, Honorare und Auslagen, welche der

Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Gründung erwachsen, werden auf ungefähr 800,- Euro geschätzt.

<i>Ausserordentliche Hauptversammlung

Die Erschienenen, welche das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital vertreten, haben unmittelbar anschließend

folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Sitz der Gesellschaft ist in L-6614 Wasserbillig, 43 rue du Bocksberg;
2. Zu den Verwaltungsratsmitgliedern wurden ernannt:
Herr Michael FEIT, Verwaltungsratsmitglied
Herr Johann FEIT, Verwaltungsratsmitglied
Herr Mario KNAUF, Verwaltungsratsmitglied und delegiertes Verwaltungsratsmitglied
Herr Heiko KRASSER, Verwaltungsratsmitglied und delegiertes Verwaltungsratsmitglied
Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder enden nach sechs Jahren.
3. Zum Wirtschaftsprüfer wird ernannt:
Die Gesellschaft FIRELUX S.A., Handelsregisternummer B 84589, mit Sitz in L - 9053 Ettelbruck, 45, Avenue J.F.

Kennedy

Das Mandat des Rechnungsprüfers endet nach sechs Jahren.

Worüber Urkunde aufgenommen wurde in Ettelbruck am Datum wie eingangs erwähnt,

102383

L

U X E M B O U R G

die nach Verlesung und Erklärung aller Vorstehenden gegenüber den Erschienenen, die dem unterzeichneten Notar

nach Namen, Zivilstand und Wohnort bekannt ist, von den Erschienenen vor dem Notar unterschrieben wurde.

Gezeichnet: Michael FEIT, Johann FEIT, Mario KNAUF, Heiko KRASSER, Pierre PROBST.
Enregistré à Diekirch, le 11 juin 2014. Relation: DIE/2014/7391. Reçu soixante-quinze euros 75,00.-€.

<i>Le Receveur pd (signé): Recken.

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Begehr und zum Zwecke der Veröffentlichung im

Memorial erteilt.

Ettelbrück, den 16. Juni 2014.

Référence de publication: 2014083546/256.
(140099384) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2014.

Imaginations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2670 Luxembourg, 21, boulevard de Verdun.

R.C.S. Luxembourg B 31.827.

<i>Extrait des résolutions de l'assemblée générale extra-ordinaire du 05 mai 2014

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide de révoquer de son poste d'administrateur:
Madame Andrée DICHTER, juriste, née à Esch/AIzette le 20 mars 1967, demeurant à L-5431 Lenningen, 17 rue des

Vignes

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de nommer comme nouveau administrateur:
Monsieur Hajime MIYAMAE, administrateur de sociétés, né à KANAGAWA-JPN, le 11 juillet 1957, demeurant à

L-2160 Luxembourg 2-4 rue Münster.

son mandat expire à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2016.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Francis Weisgerber
<i>Administrateur-délégué

Référence de publication: 2014081633/20.
(140096592) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2014.

Ukrainian Agrarian Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1430 Luxembourg, 6, boulevard Pierre Dupong.

R.C.S. Luxembourg B 161.615.

<i>Extrait de résolution de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 10.06.2014

Les actionnaires de la société UKRAINIAN AGRARIAN INVESTMENTS S.A. réunis le 10.04.2014 ont décidé ce qui

suit:

1. Nommer Monsieur Pavel DANILOV, né à Sverdlovsk Oblast, RUSSIA, le 8 mai 1982, demeurant à 41/2 Leninsky

prospect, apt. 428, 119334 Moscow, RUSSIA, au poste d'administrateur exécutif avec effet au 02.06.2014.

2. Nommer Monsieur Dmitry RAZUMOV, né à Moscow, RUSSIA, le 7 février 1975, demeurant à 1 Korobeynikov

per., apt. 15, 119034 Moscow, RUSSIA, au poste d'administrateur exécutif avec effet au 02.06.2014.

3. Prise de connaissance des démissions de Monsieur Alexander MERZLENKO de son poste d'administrateur exécutif

avec effet au 02.06.2014.

4. Prise de connaissance des démissions de Monsieur Christophe CHARLIER de son poste d'administrateur exécutif

avec effet au 02.06.2014.

Fait à Luxembourg, le 10.06.2014.

Pour extrait conforme
La société

Référence de publication: 2014082694/21.
(140097168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2014.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

102384


Document Outline

20140519 Holding S.à r.l.

3A Alternative Funds

Adinvest II (Luxembourg) Management S.àr.l.

Alex Successor SPF S.A.

Bautra S.A.

C4U2 S.A.

Dorin S.à r.l.

Eaton Holding IX S.à r.l.

EcoSol - Sanem

EDM International

Fortune Investissement S.A.

Imaginations S.A.

Inica Holding S.à r.l.

JAB Consumer Fund Management S.à r.l.

Kellogg Lux I S.à r.l.

Kempen Alternative Investment Fund

Onsen S.A.

Orion Sicav

Otra Sàrl

Patinvest S.A.

Petrova-Krivenka société en nom collectif

Polenergia International S.à r.l.

Prodiafix-Lux S.à r.l.

QSI Finance II (Lux) S.à r.l.

QSI Finance II (Lux) S.à r.l.

Ravago Chemicals S.A.

R. Coiffure S.à r.l.

Realpromo S.A.

REI SV S.à r.l.

Remae Blanche S.A.

Restaurant-Brasserie Um Dierfgen - Marc Berg S.à r.l.

Retouche Prestige S.à r.l.

Rhine Acquisitions S.à r.l.

Rhine (Luxembourg) Holdings S.à r.l.

Rorento

R.P.E. S.A.

Rubik Ventures

Silver Moss B 2014 S.à r.l.

Silver Moss C Mixed 2014 S.à r.l.

Silver Moss C Retail 2014 S.à r.l.

Simple E-Solutions S.A.

Stabilus S.A.

Tilad Bavaria Investment Company Limited

Ukrainian Agrarian Investments S.A.