This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2008
31 juillet 2014
SOMMAIRE
Amigo Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
96378
Azul Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96366
Barbara Investissements S.A. . . . . . . . . . . .
96338
Bateman Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . .
96371
Bau-Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96338
Beekman Capital Luxembourg . . . . . . . . . .
96339
Belilux Partners . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96338
BELLATRIX Asset Management S.A. . . . .
96340
Berlin 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96343
Berlin Hof 3 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96343
Berlin Hof 4-5 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96344
Bienne SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96339
Bilfinger FRB S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96340
Bodmin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96341
Bodmin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96341
BOP (Principal Place I) S.à r.l. . . . . . . . . . . .
96338
BPI Global Investment Fund Management
Company S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96342
Breva S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96338
Bugy Capital S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96375
Bugy Capital S.à r.l., SPF . . . . . . . . . . . . . . . .
96375
BV Acquisitions MX S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
96340
Caelus Energy Indonesian Holdings Sàrl
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96341
Calcipar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96349
Calimax 2 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96341
Callaghan Square (Luxembourg) Holding
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96342
Capital Safety Canada Holdings S.à r.l. . . .
96344
Cappartners S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96348
Capucins (Thionville) S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
96345
Capula ESS Lux 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
96345
Capula ESS Lux 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
96369
Cardoso Constructions S.à r.l. . . . . . . . . . . .
96349
Carmarguen Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
96349
Casaquira Holdings Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . .
96342
Cascade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96384
Cavaliere Brands S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
96344
Centre Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96345
CGFP Assurances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96349
Chemring Luxembourg Finance . . . . . . . . .
96346
Chemring Luxembourg Holding . . . . . . . . .
96346
Cherryhill Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
96346
China Designer Outlet Mall S.A. . . . . . . . . .
96342
China Designer Outlet Mall S.A. . . . . . . . . .
96339
CLdN Bulk I S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96349
CoArt S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96348
Comco MCS S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96350
Commercial Project Holdings S.à r.l. . . . .
96343
Conadau S.A.-SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96346
Covart Gallery S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96341
Crèche La Petite Sirène S.à.r.l. . . . . . . . . . .
96347
Credit Suisse Index Fund (Lux) . . . . . . . . . .
96347
Credit Suisse Real Estate Fund Internatio-
nal (Luxembourg) Holding S.A. . . . . . . . .
96348
Crosstree Real Estate Finance S.à r.l. . . . .
96345
Dialogiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96374
Dune Stratégie S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96381
Dynex Energy S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96384
Ecke Golden S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96383
Effeta Spf S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96347
Erdi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96348
E.T.T. European Trade and Transport S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96382
Retkauf III S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96350
96337
L
U X E M B O U R G
Barbara Investissements S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9053 Ettelbruck, 45, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 153.384.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014075360/10.
(140089326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2014.
Bau-Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 27.968.
Le bilan au 31.12.2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mai 2014.
Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L - 1013 Luxembourg
Référence de publication: 2014075362/14.
(140088585) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2014.
Belilux Partners, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 243, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 169.535.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2014075369/11.
(140088773) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2014.
BOP (Principal Place I) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 13.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 177.202.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mai 2014.
Référence de publication: 2014075378/10.
(140088547) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2014.
Breva S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.
R.C.S. Luxembourg B 134.783.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014075380/9.
(140089044) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2014.
96338
L
U X E M B O U R G
Beekman Capital Luxembourg, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 176.905.
EXTRAIT
Il résulte de différentes conventions que les parts sociales de la société Beekman Capital Luxembourg Sàrl ont fait
l'objet des cessions suivantes:
1. La société JDJ TWO SA a cédé 4.236 parts sociales à la société BLISCE Sàrl ayant son siège social au 412F route
d'Esch, L-1471 Luxembourg immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
174 792
2. La société NAEDO Sàrl a cédé 1.889 parts sociales à la BLISCE Sàrl ayant son siège social au 412F route d'Esch,
L-1471 Luxembourg immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 174 792
Suite à ces conventions, la répartition des parts sociales est modifiée comme suit, et ce avec effet au 06 mai 2013:
JDJ TWO SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.076 parts sociales
NAEDO Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.673 parts sociales
Beekman Reim Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
626 parts sociales
BLISCE Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.125 parts sociales
TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.500 parts sociales
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait le 25 juin 2013.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2014075366/25.
(140088719) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2014.
Bienne SA, Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 142.223.
EXTRAIT
Suite à l'Assemblée Générale ordinaire du 2 septembre 2013, le mandat d'administrateur et de Président du Conseil
d'administration de Monsieur HALLEY Olivier est reconduit pour une nouvelle période de trois ans. Son mandat viendra
à échéance lors de l'Assemblée statutaire de l'an 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mai 2014.
<i>Le Conseil d'administrationi>
Référence de publication: 2014075371/14.
(140089366) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2014.
China Designer Outlet Mall S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 168.248.
Nous vous informons dans cette lettre que nous démissions de notre mandat de commissaire de la société «China
Designer Outlet Mall S.A.» enregistrée dans le Registre de Commerce et des Sociétés (RCS) sous le numéro B168248
avec effet immédiat. Nous vous prions de bien vouloir publier ceci dans le registre de commerce et dans le mémorial si
applicable.
Nous restons à votre entière disposition pour toute question éventuelle.
Luxembourg, le 19.05.2014.
Avega Revision S.à r.l.
Représentée par Frank Thihatmar
Référence de publication: 2014075399/15.
(140088637) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2014.
96339
L
U X E M B O U R G
BELLATRIX Asset Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 126.537.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 28 avril 2014i>
L'assemblée accepte la démission de André ROELANTS (né le 25 novembre 1943 à Schaarbeeck (Belgique) et de-
meurant au 97A, route de Fischbach, L - 7447 Lintgen), de son poste d'administrateur de la société avec effet immédiat.
L'assemblée accepte la démission de Monsieur Ingo HEPP (né le 15 avril 1976 à Malmedy (Belgique) et demeurant au
36, In der Rcisbach, B - 4760 Büllingen) au poste d'administrateur de la société avec effet au 30 juin 2014.
L'assemblée accepte la nomination de Monsieur Pascal WÜRGLER (né le 29 septembre 1970 à Zurich (Suisse) et
demeurant professionnellement au 31, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg) au poste d'administrateur de la
société. Son mandat arrivera à échéance à l'issue de l'assemblée générale statutaire qui se tiendra en l'année 2015.
L'assemblée accepte la nomination de Monsieur Philippe MERMOD (né le 9 janvier 1958 à Ormont-Dessous Vaud
(Suisse) et demeurant professionnellement au 31, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg) au poste d'administrateur
de la société. Son mandat arrivera à échéance à l'issue de l'assemblée générale statutaire qui se tiendra en l'année 2015.
Monsieur Alain WÜRGLER est nommé Président du Conseil d'administration en remplacement de Monsieur André
ROELANTS, démissionnaire.
Pour extrait sincère et conforme
François HAQUENNE
<i>Administrateur déléguéi>
Référence de publication: 2014075370/23.
(140088905) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2014.
Bilfinger FRB S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6921 Roodt-sur-Syre, 4A, Banzelt.
R.C.S. Luxembourg B 62.299.
Le bilan au 31.12.2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mai 2014.
Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L - 1013 Luxembourg
Référence de publication: 2014075372/14.
(140088586) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2014.
BV Acquisitions MX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 143.315,64.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 183.452.
EXTRAIT
Suite à un déménagement,
- Madame Lizette Perez-Deisboeck, gérant A de la société susmentionnée, né le 7 décembre 1965 à Puerto Rico (USA),
demeure désormais professionnellement à l'adresse suivante: One Marina Park Drive, Suite 1100, Boston, MA 022107,
USA.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Le mandatairei>
Référence de publication: 2014075381/17.
(140089045) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2014.
96340
L
U X E M B O U R G
Bodmin, Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 160.393.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
Un administrateuri>
Référence de publication: 2014075376/11.
(140089368) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2014.
Bodmin, Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 160.393.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
Un administrateuri>
Référence de publication: 2014075377/11.
(140089369) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2014.
Caelus Energy Indonesian Holdings Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 1.050.000,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 170.758.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 28 mai 2014.
Référence de publication: 2014075384/10.
(140089401) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2014.
Calimax 2 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 24, avenue Emile Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 178.229.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 28 mai 2014.
Référence de publication: 2014075385/10.
(140088970) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2014.
Covart Gallery S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6740 Grevenmacher, 2, Kurzacht.
R.C.S. Luxembourg B 152.722.
Le bilan au 31.12.2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
<i>Pour COVART GALLERY SARL
i>Signature
Référence de publication: 2014075434/12.
(140088634) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2014.
96341
L
U X E M B O U R G
BPI Global Investment Fund Management Company S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 46.684.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires du 19 mars 2014i>
En date du 19 mars 2014, l'Assemblée Générale Annuelle a décidé:
- De prendre acte de la démission de Mme Carla Maria de Castro Chousal en date du 30 décembre 2013.
- De nommer M. Paulo Alexandre Meles Saldanha Feire de Oliveira, Rua da Trinitaria 176, P-4150-735 Porto, sous
réserve de l'approbation de La Commission de Surveillance du Secteur Financier, pour un mandat d'un an qui viendra à
échéance lors de la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2015.
- De renouveler le mandat des administrateurs suivants:
* M. Fernando Maria Costa Duarte Ulrich
* M. Manuel Maria Pimentel de Sousa e Meneses
* M. José Manuel Chaves da Veiga Sarmento
* M. João António Braga da Silva Pratas
pour un terme d'un an venant à échéance lors de la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2015.
- De renouveler le mandat du réviseur d'entreprise agréé Deloitte Audit pour un terme d'un venant à échéance lors
de la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2015.
<i>Pour BPI GLOBAL INVESTMENT FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.
i>BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - SUCCURSALE DE LUXEMBOURG
Référence de publication: 2014075379/23.
(140088953) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2014.
Callaghan Square (Luxembourg) Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 53.375,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 163.720.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mai 2014.
Référence de publication: 2014075386/10.
(140088867) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2014.
Casaquira Holdings Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 140.774.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Kariem Abdellatif.
Référence de publication: 2014075392/10.
(140088976) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2014.
China Designer Outlet Mall S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 168.248.
Par la présente j'ai l'honneur de vous informer de ma démission, avec effet au 14 mai 2014, de mes fonctions d'admi-
nistrateur de la société CHINA DESIGNER OUTLET MALL S.A. - avec siège social sis au 1, avenue de la Gare L-1611
Luxembourg et R.C.S. Luxembourg B 168.248.
Hesperange, le 13 mai 2014.
Carmine REHO.
Référence de publication: 2014075400/11.
(140088637) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2014.
96342
L
U X E M B O U R G
Berlin Hof 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 175.428.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique datées du 16 mai 2014i>
En date du 16 mai 2014, l'associé unique de la Société a pris connaissance de la démission des gérants Joost Tulkens
et Johanna van Oort avec effet immédiat.
En cette même date, l'associé unique de la Société a décidé de nommer les personnes suivantes en tant que gérants
de la Société et ce, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée:
- Jennika Lindholm, née le 16 mars 1981 à Berlin en Allemagne, demeurant professionnellement au 1, boulevard de la
Foire, L-1528 Luxembourg; et
- Kemal Akyel, né le 2 juin 1977 à Beringen en Belgique, demeurant professionnellement au 1, boulevard de la Foire,
L-1528 Luxembourg.
L'associé unique a également décidé de nommer PricewaterhouseCoopers, demeurant professionnellement au 400,
route d'Esch, L-1471 Luxembourg en tant que réviseur d'entreprises agréé, avec effet rétroactif au 25 avril 2013 et pour
une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mai 2014.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2014075341/24.
(140088826) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2014.
Berlin 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 168.446.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique datées du 16 mai 2014i>
En date du 16 mai 2014, l'associé unique de la Société a pris connaissance de la démission des gérants Johanna van
Oort et Joost Tulkens avec effet immédiat.
En cette même date, l'associé unique de la Société a décidé de nommer les personnes suivantes en tant que gérants
de la Société et ce, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée:
- Jennika Lindholm, née le 16 mars 1981 à Berlin en Allemagne, demeurant professionnellement au 1, boulevard de la
Foire, L-1528 Luxembourg; et
- Kemal Akyel, né le 2 juin 1977 à Beringen en Belgique, demeurant professionnellement au 1, boulevard de la Foire,
L-1528 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mai 2014.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2014075343/21.
(140088886) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2014.
Commercial Project Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 115.476.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014075404/9.
(140089024) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2014.
96343
L
U X E M B O U R G
Cavaliere Brands S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 42.500,00.
Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.
R.C.S. Luxembourg B 178.504.
En date du 22 mai 2014, un changement dans l'actionnariat de la Société sous rubrique est intervenu de la façon suivante:
Emerisque Cavaliere Limited. détenant 21 250 parts dans la société Cavaliere Brands S.à r.l., a transféré 21 250 parts
à Emerisque Luxembourg S.à r. l. ayant son siège social au 2 rue des Dahlias L-1411 Luxembourg
Suite à ce transfert, les 42 500 parts sociales représentant l'intégralité du capital social de la société sont réparties
comme suit:
Cavaliere Holdings S.à r.l.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 250 parts
Emerisque Luxembourg S.à r.l.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 250 parts
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 500 parts
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Christophe Cahuzac
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2014075393/20.
(140088721) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2014.
Berlin Hof 4-5 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 162.743.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique datées du 16 mai 2014i>
En date du 16 mai 2014, l'associé unique de la Société a pris connaissance de la démission du gérant unique Intertrust
Management (Luxembourg) S.à r.l. avec effet immédiat.
En cette même date, l'associé unique de la Société a décidé de nommer les personnes suivantes en tant que gérants
de la Société et ce, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée:
- Jennika Lindholm, née le 16 mars 1981 à Berlin en Allemagne, demeurant professionnellement au 1, boulevard de la
Foire, L-1528 Luxembourg; et
- Kemal Akyel, né le 2 juin 1977 à Beringen en Belgique, demeurant professionnellement au 1, boulevard de la Foire,
L-1528 Luxembourg.
L'associé unique a également décidé de nommer PricewaterhouseCoopers, demeurant professionnellement au 400,
route d'Esch, L-1471 Luxembourg en tant que réviseur d'entreprises agréé, avec effet rétroactif au 25 avril 2013 et pour
une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mai 2014.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2014075342/24.
(140088817) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2014.
Capital Safety Canada Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollligergrund.
R.C.S. Luxembourg B 185.360.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 28 mai 2014.
Référence de publication: 2014075388/10.
(140088795) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2014.
96344
L
U X E M B O U R G
Capucins (Thionville) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.942.200,00.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 163.965.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 28 mai 2014.
Référence de publication: 2014075389/10.
(140088813) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2014.
Capula ESS Lux 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 7, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 177.365.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Référence de publication: 2014075390/10.
(140088859) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2014.
Centre Europe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 43, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 90.546.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 25 mars 2014i>
L'associé unique renouvelle le mandat de la société ERNST & YOUNG comme Commissaire aux comptes de la société
Centre Europe S.A. pour la période du 01/01/2014 au 31/12/2014.
L'adresse de ERNST & YOUNG est 7, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2, L-5365 Munsbach.
L'associé unique renouvelle pour une durée de 3 ans le mandat d'administrateur de Monsieur Guillaume de Groot-
Herzog, né à Esch-sur-Alzette le 3 avril 1960 et dont l'adresse professionnelle est au 43, Boulevard Royal à L-2955
Luxembourg. Son mandat viendra à échéance à l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2017 pour approuver les comptes
annuels de l'exercice 2016.
Luxembourg, le 25 mars 2014.
Certifié sincère et conforme
<i>Pour Centre Europe S.A.
i>Olivier HUBERT / Siegfried MARISSENS
<i>Administrateur / Présidenti>
Référence de publication: 2014075394/20.
(140089292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2014.
Crosstree Real Estate Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 172.804.
Le Bilan et l’affectation du résultat au 31 Décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mai 2014.
Crosstree Real Estate Finance S.à.r.l.
Patrick L.C. van Denzen
<i>Manager Bi>
Référence de publication: 2014075411/14.
(140089116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2014.
96345
L
U X E M B O U R G
Chemring Luxembourg Finance, Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 305.021.733,94.
Siège social: L-1445 Strassen, 1A, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 152.586.
Le bilan au 31 octobre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mai 2014.
Référence de publication: 2014075396/10.
(140088943) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2014.
Chemring Luxembourg Holding, Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 207.001.923,59.
Siège social: L-1445 Strassen, 1A, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 152.588.
Le bilan au 31 octobre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mai 2014.
Référence de publication: 2014075397/10.
(140088942) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2014.
Cherryhill Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 125.549.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Schuttrange, le 28 mai 2014.
Signature.
Référence de publication: 2014075398/10.
(140089288) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2014.
Conadau S.A.-SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1748 Luxembourg, 7, rue Lou Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 149.775.
EXTRAIT
L'assemblée générale du 26 mai 2014 a renouvelé les mandats des administrateurs.
- Mr Mirko von RESTORFF, Administrateur de catégorie A, Président, administrateur de sociétés, 11, rue de l'Europe,
L-7225 Bereldange, Luxembourg;
- Mr André BALDAUFF, Administrateur de catégorie B, diplômé ESC Paris, 75, rue Jean-François Boen, L-1244 Lu-
xembourg, Luxembourg;
- Mr Henri GRISIUS, Administrateur de catégorie B, licencié en sciences économiques appliquées, 30, rue Joseph
Hansen, L-1716 Luxembourg, Luxembourg.
Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2014.
L'assemblée générale du 26 mai 2014 a pris note du non-renouvellement de candidature de Monsieur Hans-Jürgen
SALBACH aux fonctions de commissaire aux comptes et nomme en remplacement;
- INTERAUDIT, société à responsabilité limitée, 37, rue des Scillas, L-2529 Howald, immatriculée au Registre de
Commerce et des Société sous le numéro B29501.
Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2014.
Luxembourg, le 26 mai 2014.
<i>Pour CONADAU S.A.- SPF
i>Société anonyme de Gestion de Patrimoine Familial
Référence de publication: 2014075428/24.
(140088197) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2014.
96346
L
U X E M B O U R G
Crèche La Petite Sirène S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1321 Luxembourg, 115, rue de Cessange.
R.C.S. Luxembourg B 76.294.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014075408/9.
(140088691) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2014.
Credit Suisse Index Fund (Lux), Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 167.524.
L'assemblée générale ordinaire du 21 mai 2014 a décidé de renouveler les mandats de Messieurs Rudolf Kömen, Guy
Reiter et Fernand Schaus et de nommer Messieurs Dominique Délèze et Josef H.M. Hehenkamp en tant que nouveaux
membres du conseil d'administration. L'assemblée prend également note de la démission de M. Luca Diener.
Par conséquent, le conseil d'administration se compose comme suit et ce jusqu'à la fin de la prochaine assemblée
générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2015:
- Dominique Délèze, Membre du Conseil d'Administration
Kalanderplatz 1, CH-8045 Zurich
- Josef H.M. Hehenkamp, Membre du Conseil d'Administration
Kalanderplatz 1, CH-8045 Zurich
- Rudolf Kömen, Membre du Conseil d'Administration
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
- Guy Reiter, Membre du Conseil d'Administration
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
- Fernand Schaus, Membre du Conseil d'Administration
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
PricewaterhouseCoopers a été réélu comme réviseur d'entreprises, et ce jusqu'à la fin de la prochaine assemblée
générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A.
Référence de publication: 2014075409/26.
(140089416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2014.
Effeta Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 39.157.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 23 avril 2014i>
- L'assemblée générale ordinaire renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Gérard Deprez, ingénieur
technicien, demeurant 95, Engelendalelaaan à B-8310 Assebroek-Brugge, Lux Konzern S.à r.l., ayant son siège social 40
Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, ayant pour représentant permanent Monsieur Peter van Opstal, et de Lux Bu-
siness Management S.à r.l., ayant son siège social 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg, ayant pour représentant
permanent Monsieur Christian Knauff, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant
son siège social 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera
sur les comptes de l'exercice 2014.
Luxembourg, le 23 avril 2014.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2014075493/19.
(140088830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2014.
96347
L
U X E M B O U R G
CoArt S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 100.605.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mai 2014.
Référence de publication: 2014075406/10.
(140088922) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2014.
Credit Suisse Real Estate Fund International (Luxembourg) Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 104.654.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mai 2014.
Référence de publication: 2014075410/10.
(140088869) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2014.
Cappartners S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.
R.C.S. Luxembourg B 97.802.
Il résulte du procès-verbal d'une réunion du Conseil d'Administration de la Société tenue en date du 28 mai 2014 que
les administrateurs, M. Fernand HEIM, M. Marc SCHMIT et Mme Annie SWETENHAM ainsi que le commissaire aux
comptes, M. Marco RIES, se sont démis de leurs fonctions respectives avec effet immédiat.
Luxembourg, le 28 mai 2014.
Pour extrait conforme
SG AUDIT Sàrl
Référence de publication: 2014075413/13.
(140089060) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2014.
Erdi S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 22.385.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 23 mai 2014 que:
Les administrateurs suivants ont démissionnés:
- Madame Mireille GEHLEN
- Madame Chantal MATHU
- Monsieur Thierry JACOB
L'Assemblée décide de nommer en leur remplacement, et ceci jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire prévue en
2018:
- Monsieur Stéphane DE JONGHE, né le 08 février 1974 à Etterbeek (Belgique), demeurant professionnellement au
11, boulevard Albert 1
er
, MC-98000 Monaco
L'Assemblée prend également acte de la démission du Commissaire aux comptes actuel, à savoir, FIN-CONTROLE
S.A. et décide de nommer en son remplacement et ceci pour la même période:
- FN-SERVICES S.àr.l, avec siège social au 61, Gruuss-Strooss, L-9991 Weiswampach.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2014075505/21.
(140089210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2014.
96348
L
U X E M B O U R G
Calcipar S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.
R.C.S. Luxembourg B 22.611.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014075412/10.
(140089203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2014.
Cardoso Constructions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1630 Luxembourg, 46, rue Glesener.
R.C.S. Luxembourg B 127.531.
Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014075414/10.
(140089335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2014.
Carmarguen Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.
R.C.S. Luxembourg B 88.705.
Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014075415/9.
(140089222) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2014.
CGFP Assurances, Société Anonyme.
Siège social: L-1468 Luxembourg, 16, rue Erasme.
R.C.S. Luxembourg B 166.988.
Les Comptes annuels révisés au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bertrange, le 28 mai 2014.
CGFP Assurances
Daniel FRANK
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2014075423/14.
(140088660) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2014.
CLdN Bulk I S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 3-7, rue Schiller.
R.C.S. Luxembourg B 160.578.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
P. Traen / M. Jadot
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2014075424/11.
(140089384) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2014.
96349
L
U X E M B O U R G
Comco MCS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1274 Howald, 40, rue des Bruyères.
R.C.S. Luxembourg B 41.488.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014075426/10.
(140088977) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2014.
Retkauf III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1229 Luxembourg, 15, rue Bender.
R.C.S. Luxembourg B 123.225.
In the year two thousand and fourteen, on the twentieth day of June.
Before us, Maitre Jean SECKLER, notary, residing in Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).
THERE APPEARED:
1. Investec GLL SGO REF Holding Alpha S.à r.l., a private limited liability company incorporated and organised under
the laws of the Grand Duchy of Luxembourg with registered office 15, rue Bender, L-1229 Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg, currently holding two hundred eighteen (218) shares of the Company,
here duly represented by Henri DA CRUZ, employee, with professional address in Junglinster, by virtue of a proxy
given on 18 June 2014, and
2. GLL Management Company S.à r.l., a private limited liability company incorporated and organised under the laws
of the Grand Duchy of Luxembourg with registered office 15, rue Bender, L-1229 Luxembourg, Grand Duchy of Lu-
xembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 116672, acting in
its own name and on behalf of GLL Retail Center I, FCP-FIS, a fonds commun de placement fonds d'investissement
spécialisé, which is established and exists under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered on the official
list of special investment funds governed by Luxembourg law of 13 February 2007 on specialised investment funds, as
amended, and currently holding two hundred eighty-two (282) shares of the Company,
here duly represented by Henri DA CRUZ, employee, with professional address in Junglinster, by virtue of a proxy
given on 18 June 2014.
The said proxies, signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned notary, will
remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing parties being the shareholders ("Shareholders") of the company "Retkauf III S.à r.l.", a société a res-
ponsabilité limitée, having its registered office at 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, registered with the Register
of Commerce and Companies ("RCS") under number B 123225 incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger
on 19 December 2006, published in the Memorial C, Recueil des Societes et Associations number 287, page 13749 on 2
March 2007 (the "Company"). The Articles of the Company were amended for the last time on 14 February 2013 pursuant
to a deed of the notary Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg, published
in the Mémorial C number 873, page 41860, on 12 April 2013.
The appearing parties, representing the whole corporate capital take the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Shareholders hereby resolve to transfer the registered office of the Company from its current address at 6A,route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, to 15, rue Bender, L-1229 Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg at 15, rue Bender, L-1229 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
<i>Second resolutioni>
The Shareholders resolve to amend and fully restate the articles of incorporation of the Company, which will hence-
forth read as follows:
Chapter I. - Form, Name, Registered office, Object, Duration
1. Form - Corporate name. The Company exists as a private limited liability company under Luxembourg law under
the name "Retkauf III S.à r.l." (hereafter referred to as the "Company"), governed by the laws pertaining to such an entity,
and in particular by the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended from time to time (hereafter referred
to as the "Law"), as well as by the present articles of incorporation (hereafter referred to as the "Articles").
2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg.
96350
L
U X E M B O U R G
2.2 It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an
extraordinary general meeting of its Shareholders (as defined hereafter) deliberating in the manner provided for amend-
ments to the Articles.
2.3 However, the Sole Manager (as defined hereafter) or, in case of plurality of managers, the Board of Managers (as
defined hereafter) of the Company is authorised to transfer the registered office of the Company within the City of
Luxembourg.
2.4 Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would
prevent the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be tem-
porarily transferred abroad until such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will however
not have any effect on the nationality of the Company. The decision as to the transfer abroad of the registered office will
be made by the Sole Manager (as defined hereafter) or, in case of plurality of managers, the Board of Managers (as defined
hereafter).
3. Object.
3.1 The purpose of the Company is to (directly or indirectly) acquire, finance, hold and exchange or sell securities of
other entities (having legal personality or not) holding properties either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad
by way of, among others, the subscription or the acquisition of any securities and rights through participation, contribution,
underwriting, firm purchase or option, negotiation or in any other way, and to administrate, develop and manage such
holding of interests.
3.2 The Company may provide financial debt instruments in any form whatsoever to the entities in which it holds a
direct or indirect interest or which form part of the same group of companies as the Company, such as the loans and
guarantees of securities in any kind or form. The Company may borrow in any kind or form and privately issue bonds,
notes or similar debt instruments.
3.3 The Company may further use its funds for the acquisition, development, sale, management and/or lease of real
estate either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as for any other operations relating to real estate.
3.4 The Company may also carry out any commercial, industrial, financial, movable and immovable operations, which
are in direct or indirect relation with its object or which may deem useful in the accomplishment and development of its
purposes.
4. Duration. The Company is incorporated for an unlimited period.
Chapter II. - Capital, Shares
5. Share capital.
5.1 The corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by twelve thousand
five hundred (12,500) shares with a nominal value one euro (EUR 1) each (hereafter referred to as a "Share" and collec-
tively as the "Shares"). The holders of the Shares are together referred to as the "Shareholders" or solely the
"Shareholder".
5.2 In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account (the "Premium Account"), into which
any premium paid on any Share or any other contribution made without the issuance of Shares is transferred. The amount
of said Share Premium Account is at the free disposal of the Shareholder(s). The amount of the premium account may
be used to make payment for any Shares, which the Company may redeem from its Shareholder(s), to offset any net
realized losses, to make distributions to the Shareholder(s) or to allocate funds to the legal reserve.
5.3 All Shares will have equal rights.
5.4 The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the limits set by the Law.
6. Shares indivisibility. Towards the Company, the Shares are indivisible, so that only one owner is admitted per Share.
Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
7. Transfer of shares.
7.1 A transfer of Shares shall generally only be allowed to a corporate body.
7.2 Pre-emption Right
(a) Within 18 months as from 20 June 2014, the Shares may be transferred only to a Qualified Transferee (as defined
below) and each Shareholder shall have a pre-emption right for the Shares of the other Shareholder.
(b) Qualified Transferee means an institutional investor having sufficient financial resources to cover all obligations
arising from its position as a Shareholder ("Qualified Transferee"). The financial status of the Qualified Transferee shall
be proven by its annual financial statements and turnover for the last three business years and / or appropriate financial
guarantee.
(c) If a Shareholder intends to make a binding offer to sell its Shares to a Qualified Transferee ("Initiating Shareholder"),
or receives a binding offer to purchase its Shares from a Qualified Transferee and such Initiating Shareholder decides to
sell such Shares, the Initiating Shareholder shall first make a written offer ("Offer") to sell such Shares to the other
Shareholder ("Offeree") on the same terms and conditions as the Initiating Shareholder intends to sell to the Qualified
96351
L
U X E M B O U R G
Transferee. The Offer shall contain all specific and detailed information relating to the proposed sale by the Initiating
Shareholder to the Qualified Transferee.
(d) If the Offeree intends to accept the Offer, it shall give written notice to the Initiating Shareholder within forty-five
(45) days upon the receipt of the Offer. The sale and purchase agreement between the Initiating Shareholder and the
Offeree for all, but not less than all, of the Shares which are the subject of the Offer shall come into existence upon
receipt by the Initiating Shareholder of the written notice of the Offeree accepting the Offer.
(e) If the Offeree does not give written notice of its intention to purchase the Shares pursuant to the Offer within
forty-five (45) days of receipt by the Offeree of the Offer, the Offeree shall be deemed to have refused the Offer and
have not exercised its pre-emption right.
(f) After the expiry of the forty-five (45) days period set out in clause 7.2.(d) without the Offeree expressing its intention
to purchase the Shares, the Initiating Shareholder shall have the right to sell not less than all of the Shares specified in the
Offer to the Qualified Transferee on terms and conditions no more favourable to the Qualified Transferee than the terms
and conditions set forth in the Offer.
(g) The Offeree may appoint a member of its Group (the "Group") to exercise the pre-emption right. For the sake of
clarity, Group shall include for the purpose of this clause any subsidiary of the unitholders / shareholders of the Share-
holders.
7.3 Right of First Offer
(a) Upon expiry of the 18 months period as from 20 June 2014, each Shareholder shall have a right of first offer for
the Shares of the other Shareholder in accordance with this clause 7.3.
(b) If the Initiating Shareholder intends to make a non-binding offer to sell its Shares to a third party potential purchaser
("Potential Purchaser"), or receives a non-binding offer to purchase its Shares from a Potential Purchaser and such Initiating
Shareholder decides to sell such Shares, the Initiating Shareholder shall first make an Offer to sell such Shares to the
Offeree on the same terms and conditions as the Initiating Shareholder intends to sell to the Potential Purchaser. The
Offer shall only contain the total amount of the Shares to be sold and the sale price relating to the prosposed sale by the
Initiating Shareholder to the Potential Purchaser.
(c) If the Offeree intends to accept the Offer, it shall give written notice to the Initiating Shareholder within forty-five
(45) days upon the receipt of the Offer. The sale and purchase agreement between the Initiating Shareholder and the
Offeree for all, but not less than all, of the Shares which are the subject of the Offer shall come into existence upon
receipt by the Initiating Shareholder of the written notice of the Offeree accepting the Offer.
(d) If the Offeree does not give written notice of its intention to purchase the Shares pursuant to the Offer within
forty-five (45) days of receipt by the Offeree of the Offer, the Offeree shall be deemed to have refused the Offer and
have not exercised its right of first offer.
(e) After expiry of the forty-five (45) days period set out in clause 7.3 (d) without the Offeree expressing its intention
to purchase the Shares, the Initiating Shareholder shall, for a period of six (6) months from the date of the receipt of the
Offer by the Offeree, have the right to sell not less than all of the Shares specified in the Offer to the Potential Purchaser
or any third party at a price which is at least 95% of the price mentioned in the Offer and on terms and conditions no
more favourable to the Potential Purchaser (or any third party) than the terms and conditions set forth in the Offer.
(f) The Offeree may appoint a member of its Group to exercise the right of first offer. For the sake of clarity, Group
shall include for the purpose of this clause any subsidiary of the unitholders / shareholders of the Shareholders.
7.4 Intra-Group Transfer
(a) Shareholders may freely transfer their Shares to a member of their Group. For the sake of clarity, Group shall
include for the purpose of this clause any subsidiary of the unitholders / shareholders of the Shareholders.
(b) In the event of a transfer by a Shareholder of its Shares to a member of the Group of such Shareholder ("New
Shareholder") the transferring Shareholder ("Transferor") shall undertake direct surety to the other Shareholder for the
obligations of such New Shareholder under this Agreement.
(c) The Transferor and the New Shareholder shall notify the other Shareholder of the New Shareholder ceasing to
be a member of the Transferor's Group und the transferor shall reacquire such Shares from the New Shareholder (or
such Shares shall be retransferred to the Transferor, as the case may be, immediately prior to the New Shareholder
ceasing to be a member of the Transferor's Group). Transfer agreements in respect of a transfer of Shares to a member
of the Shareholder's Group shall include effective and enforceable provisions requiring the transferor to reacquire such
Shares from the New Shareholder and the obligation of the New Shareholder to resell and retransfer such shares to the
Transferor if the New Shareholder ceases to be a member of the Transferor's Group. No transfer of Shares to a member
of the transferor's Group may take effect unless and until the Transferor evidences to the other Shareholder that it has
fully complied with the obligations set out in this clause 7.4. Each Shareholder shall provide to the other Shareholder such
information as the other may reasonably need to ascertain that the New Shareholder has not ceased to be a member of
the Transferor's Group.
96352
L
U X E M B O U R G
Chapter III. - Management
8. Management.
8.1 The Company is managed by one manager (the "Sole Manager") or several managers. If several managers have been
appointed, they will constitute a board of managers (the "Board of Managers", each member individually, a "Manager").
The Sole Manager or the members of the Board of Managers, as the case may be, need not be shareholder.
8.2 The Sole Manager or the members of the Board of Managers may be removed at any time by decision of the
extraordinary general meeting of the Shareholders taken in compliance with Chapter IV.
8.3 Any decision in connection with the management of the Company shall be taken by the Sole Manager or, in case
of plurality of managers, collectively by the Board of Managers in compliance with Article 12.
8.4 Towards third parties, the general power of representation of the Company is granted to the Sole Manager and
in case of plurality of managers, to any two Managers as provided by Article 10 of the Articles, and pursuant to Article
191 bis paragraph 5 of the Law, any deed, agreement or generally any document executed in compliance with Articles 8
and 10 of the present Articles are valid and binding vis-à-vis third parties. The exercise of the general power of repre-
sentation by any two Managers does not require prior approval by the Board of Managers acting collectively.
8.5 The Managers may not, by reason of their mandate, be held personally held liable for any commitments validly
made by them in the name of the Company, provided such commitments comply with the Articles and the Law.
Without prejudice to the preceding paragraph, the limitation period for any action that may be brought by the Company
against any Manager shall be one year, unless a decision has been taken by Shareholders to discharge the Sole Manager
or, in case of plurality of managers, the Management Board from liabilities in accordance with Article 13.9 before expiry
of such one year limitation period, in which case the enforceability of claims against the Managers ceases upon the
Shareholders granting such discharge.
8.6 The Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers shall be assisted by a joint Advisory
Board.
The Advisory Board will comprise up to 10 members formally appointed the Sole Manager or, in case of plurality of
managers, the Board of Managers (the "Advisory Board Members" or solely the "Advisory Board Member").
Advisory Board Members shall be determined by way of a look-through procedure determing the indirect participation
of the ultimate investors of the Shareholders ("Ultimate Investors") ("Indirect Participation"). For the purpose of the
determination of the Indirect Participation, the Shareholders are therefore deemed transparent with regard to the right
of representation in the Advisory Board.
The Indirect Participation shall be determined according to the following formula:
IP = S x I
Whereas:
IP = Indirect Participation
S = % of shareholding of respective Shareholder in the Company
I = % of investment of Ultimate Investor in the respective Shareholder
Ultimate Investors whose Indirect Participation exceed 10.00 % are entitled to dispatch a representative to the Ad-
visory Board. For the avoidance of doubt, no Ultimate Investor may appoint more than one Advisory Board Member,
regardless of the size of its Indirect Participation. The voting rights of the Advisory Board Members are equal to the
Indirect Participation of the Ultimate Investor.
There will be no quorum for the meetings of the Advisory Board, however major decisions as mentioned under a-f
of this clause 8.6 require the approval of 60% of the existing voting rights of the Advisory Board. If the required majority
of 60% of the existing voting rights is not achieved, a second meeting shall be convoked within 20 business days in order
to re-discuss the issue presented based on further information and documentation to be provided.
If the required majority of 60% of the existing voting rights of the Advisory Board is not achieved in the second meeting,
the procedure as described under 8.7 will apply.
The Advisory Board will generally meet in Luxembourg. The Advisory Board shall meet upon a call from the Sole
Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers, the chairman of the Advisory Board or by any
Advisory Board member and shall meet at least every year.
The Advisory Board members shall vote in writing or meet by phone or in-person following upon not less than five
(5) Bank Business Days’ notice (unless waived by each Advisory Board member in writing) of the matters to be considered
and discussed by the Advisory Board.
Unless the Advisory Board votes in writing, the minutes of the Advisory Board meeting shall be signed by the chairman
of the Advisory Board.
Advisory Board members may appoint proxies to attend meetings to the extent permissible under applicable law.
The Advisory Board shall give its prior approval to the Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of
Managersbefore the Board of Managers decide about one of the following points for the Company:
a) Potential new investments other than the investments in the Company
96353
L
U X E M B O U R G
b) Disposal of investments
c) any conflict of interests referred to it by the Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers
d) any specific matters which, upon decision of the General Meeting of Shareholders, must be submitted for the
approval of the Advisory Board.
e) Mortgaging or encumbering the Properties or a Property held by the Company other than the initial mortgaging or
encumbering performed in relation to the acquisition of the Company by the Shareholders or any such mortgaging or
encumbering that may be required for the acquisition of the Company by the Shareholders;
f) Any financing or refinancing in excess of the financing by the Shareholders in relation with the acquisition of the
Company by the Shareholders and back-to-back financing via shareholder loans granted by the Shareholders (including
Investec GLL Special Opportunities Real Estate Fund, FCP-FIS) to the Company.
8.7 A Drag Along Event shall be deemed to have occurred in respect of those matters as mentioned under clause 8.6.
b) above requiring the Advisory Board’s approval if:
i. disposal of investments is required due to the expiration of the lifetime of GLL Retail Center I, FCP-FIS or Investec
GLL Global Special Opportunities Real Estate Fund (the "Funds"), and
ii. the Fund(s) has / have not shortened their lifetimes, or
iii. The second meeting of the Advisory Board failed to achieve the required 60% majority of the existing voting rights
of the Advisory Board to agree on the disposal of the respective investments.
(a) A Drag Along Event as defined above under i.-iii. shall not occur before 29 May 2017. The Shareholders be obliged
to meet at least once within the month following the second meeting to negotiate the Drag Along Event. If the Drag
Along Event cannot be resolved by the Advisory Board within one month after the second meeting as described under
8.6 (which, for the avoidance of doubt in the case of an Advisory Board's refusal to consent shall be the date of the
Advisory Board meeting or the date of the circular resolution of the Advisory Board not achieving the majority requi-
rement as set out under 8.6 (should the circular resolution consist of several separate documents, the date of the last
received resolution shall be decisive), the Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managersshall
determine the value of the Shares in the Company. For this purpose the Sole Manager or, in case of plurality of managers,
the Board of Managersshall procure a current value of the investment properties ("Current Value") of the Company. The
Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers shall propose a list of at least three knowledgeable,
independent and reputable third party appraisers (together the "Independent Appraisers" or solely the "Independent
Appraiser") to the Advisory Board. In case the Advisory Board appoints a single Independent Appraiser with 60% majority
of the existing voting rights this Independent Appraiser shall be engaged by the Sole Manager or, in case of plurality of
managers, the Board of Managersto determine the "Current Value" and the (Final) Drag Along Price. In case the Advisory
Board does not appoint a single Independent Appraiser, the Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board
of Managersshall engage three Independent Appraisers to value the assets with the average of all three valuations used
to determine the Current Value and to establish the Drag Along Prices.
(b) The valuation of the Shares shall be carried out according to the following formula and shall determine the Drag
Along Price of the Shares in the Company to be established by each Independent Appraiser (the "Drag Along Prices"):
- the last IFRS equity adjusted for the cash flow from operations, but without gains/losses from property dispositions
and non-amortized acquisition costs
- less the book value of the investment properties
- plus the Current Value
- less distributions from realized dispositions
- less disposition and liquidation costs of the Company
(c) After determination of the Drag Along Prices and if three Independent Appraisers have been engaged, the Drag
Along Prices established by the Independent Appraisers shall be compared by the Sole Manager or, in case of plurality of
managers, the Board of Managersand if the deviation, if any, of the Drag Along Prices established by the Independent
Appraisers does not exceed 10.00%, the Final Drag Along Price shall be the average of all three Drag Along Prices as
established by the Independent Appraisers.
(d) In case the deviation between the Drag Along Prices established by the Independent Appraisers exceeds 10.00%,
the Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managersshall appoint a fourth Independent Appraiser
(the "Fourth Independent Appraiser") who will perform an assessment on which Drag Along Prices established by the
Independent Appraisers rather mirrors his valuation assessment. According to the assessment of the Fourth Independent
Appraiser such Drag Along Price shall be the Final Drag Along Price.
(e) The Shareholder for whom the Drag Along Event is confirmed according to a. above (the "First Shareholder") may
serve a notice ("Offer Notice") in writing on the other Shareholder (the "Second Shareholder") offering to transfer to
the Second Shareholder the Shares in the Company for the time being held by the First Shareholder (the "First Sale
Shares") for the Final Drag Along Price. The Second Shareholder may accept the Offer Notice itself or may appoint a
member of its Group to purchase the First Sale Shares. For the sake of clarity, Group shall include for the purpose of
this clause any subsidiary of the unitholders / shareholders of the Shareholders.
96354
L
U X E M B O U R G
(f) The First Shareholder shall serve a copy of the Offer Notice on the Company at the same time as the Offer Notice
is served on the Second Shareholder.
(g) The Second Shareholder or the respective appointed Group member shall notify the First Shareholder in writing
within 20 Business Days from the date of receipt of the Offer Notice whether or not it is willing to purchase the First
Sale Shares on the terms and conditions set out in the Offer Notice.
(h) If the Second Shareholder or the respective appointed Group member gives notice in writing to the First Share-
holder that it is willing to purchase the First Sale Shares on the terms and conditions set out in the Offer Notice, the
First Shareholder shall be obliged to transfer the First Sale Shares to the Second Shareholder or the respective appointed
Group member at the Final Drag Along Price. The Second Shareholder or the respective appointed Group member shall
within 20 Business Days after giving notice in writing to the First Shareholder, pay to the First Shareholder the price set
out in the Offer Notice for the First Sale Shares and the First Shareholder shall deliver within 15 Business Days upon
receipt of the Final Drag Along Price to the Second Shareholder or the respective appointed Group member duly executed
transfers in favour of the Second Shareholder and the share certificate(s) representing the First Sale Shares. The Final
Drag Along Price shall be subject to a post closing price adjustment based on audited closing IFRS financial statements.
(i) If the Second Shareholder gives notice in writing to the First Shareholder that it is not willing to purchase the First
Sale Shares on the terms and conditions set out in the Offer Notice ("Negative Notice"), the Exit Procedure according
to the Joint Venture Agreement entered into between the Shareholders and Investec GLL Fund Management Company
S.A. acting in its own name but on behalf of Investec GLL Global Special Opportunities Real Estate Fund ("Joint Venture
Agreement") shall be started.
(j) If, after the expiry of the 20 Business Day period referred to above, the Second Shareholder has not given any notice
in writing to the First Shareholder in accordance with sub clause h. above, the Second Shareholder shall be deemed to
have refused the offer made by the First Shareholder and thus the Exit Procedure in accordance with the Joint Venture
Agreement shall be started.
9. Powers of the sole manager or of the board of managers.
9.1 In dealing with third parties, the Sole Manager and in case of plurality of managers, the Board of Managers, without
prejudice to Articles 8 and 10 of the present Articles, will have all powers to act in the name of the Company in all
circumstances and to carry out and approve all transactions and other operations consistent with the Company’s objects.
9.2 All powers not expressly reserved by law or by the Articles to the general meeting of Shareholders fall within the
competence of the Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers.
10. Representation of the company. Towards third parties, the Company will be bound in all circumstances (i) by the
individual signature of the Sole Manager; (ii) in case more than one Manager has been appointed, by the joint signatures
of any two Managers; or (iii), as the case may be, by the joint or single signature(s) of any person(s) to whom such signatory
power has been validly delegated in accordance with the Articles.
11. Delegation and agent of the sole manager or of the board of managers.
11.1 The Sole Manager or any two Managers in case of plurality of managers may delegate powers for specific tasks
to one or more ad hoc agents.
11.2 The Sole Manager or any two Managers in case of plurality of managers will determine any such agent’s respon-
sibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of its
agency.
12. Meeting of the board of managers.
12.1 In case of a Board of Managers, the meetings of the Board of Managers are convened by any Manager and at the
place indicated in the convening notice. Written notice (including via e-mail) of any meeting of the Board is given to all
Managers at least fourty-eight (48) hours in advance, except in case of emergency, the nature and circumstances of which
are set forth in the notice of the meeting.
12.2 No notice is required if all the members of the Board are present or represented and if they state to have full
knowledge of the agenda of the meeting. Notice of a meeting may also be waived in writing (including via e-mail or similar
electronic transmission) by a Manager, either before or after a meeting. Separate written notices are not required for
meetings that are held at times and places indicated in a schedule previously adopted by the Board, or determined in a
prior meeting as documented in the related Board minutes.
12.3 Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by telegram, fax, e-mail
or letter another Manager as his proxy. A Manager may also appoint by phone another Manager to represent him, which
shall be confirmed in writing at a later stage.
12.4 The Board of Managers shall choose from amongst its members a chairman (the "Chairman"). The Chairman shall
preside at all meetings of the Board. In his absence or incapacity to act, the Managers present may appoint anyone of
them to act as chairman for the purpose of the meeting (chairman pro tempore).
12.5 The Board of Managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.
The resolutions by the Board of Managers are validly adopted if approved by the majority of its members.
96355
L
U X E M B O U R G
12.6 The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating
Manager is able to hear and to be heard by all other participating members of the Board of Managers whether or not
using this technology, and each so participating Manager shall be deemed to be present and shall be authorised to vote
by video or by telephone.
12.7 Written resolutions of the Board of Managers can be validly taken if approved in writing and signed by all the
members of the Board of Managers. Such approval may be in a single or in several separate documents sent by fax, e-
mail, or by similar means. These resolutions shall have the same effect as resolutions voted at the Board of Managers'
meetings, physically held. Written resolutions become valid on the date of the last signature by a Manager or, in case of
partially or fully undated signatures, on the date of receipt of the last signed resolutions at the registered office of the
Company.
12.8 Votes may also be cast by fax, e-mail, phone or similar means provided in such latter event such vote is confirmed
in writing. The minutes signed in accordance with the Articles and documenting the subject vote are considered to be
such confirmation in writing.
12.9 The minutes of a meeting of the Board of Managers shall be signed by the Chairman or, in his absence, the chairman
pro tempore of the meeting, or at least two members of the Board of Managers present or represented at the meeting.
Extracts shall be certified by any Manager or by any person nominated by any Manager or during a meeting of the Board
of Managers.
12.10 In case of a Sole Manager, the resolutions of the Sole Manager may be documented in writing.
Chapter IV. - General meeting of shareholders
13. Powers of the general meeting of shareholder(s), Constitution and holding of meetings, - Votes.
13.1 Resolutions of the Shareholders are adopted at a general meeting of Shareholders (the "General Meeting") or by
way of circular resolutions (the "Shareholders Circular Resolutions").
13.2 Where resolutions are to be adopted by way of Shareholders Circular Resolutions, the text of the resolutions is
sent to all the Shareholders, in accordance with the Articles. Shareholders Circular Resolutions signed by all the Share-
holders are valid and binding as if passed at a General Meeting duly convened and held and bear the date of the last
signature.
13.3 Each share entitles to one (1) vote.
13.4 The Shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing at the initiative of any Manager or
Shareholders representing more than one-half of the share capital.
13.5 Written (including via e-mail) notice of any General Meeting is given to all Shareholders at least five (5) days in
advance of the date of the meeting, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in
the notice of the meeting.
13.6 General Meetings are held at such place and time specified in the notices.
13.7 If all the Shareholders are present or represented and consider themselves as duly convened and informed of the
agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice.
13.8 A Shareholder may grant a written power of attorney to another person, whether or not a Shareholder, in order
to be represented at any General Meeting.
13.9 Whatever the number of Shareholders, the balance sheet and profit and loss account shall be submitted to the
Shareholders for approval who also shall vote specifically as to whether discharge is to be given to the Sole Manager or,
in case of plurality of managers, to the Board of Managers.
14. Sole shareholder.
14.1 Where the number of Shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers conferred
by the Law to the General Meeting.
14.2 Any reference in the Articles to the Shareholders and the General Meeting or to Shareholders Circular Resolu-
tions is to be read as a reference to such sole shareholder or the resolutions of the latter, as appropriate.
14.3 The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.
15. Majorities.
15.1 Collective decisions are only validly taken insofar as Shareholders owning more than half of the share capital adopt
them. If that figure is not reached at the first meeting or first written consultation, the Shareholders may be convened
or consulted a second time, by registered letter, and decisions shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless
of the portion of capital represented.
15.2 Resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority (in number) of the Shareholders owning at
least three-quarters of the Company’s share capital, in accordance with any provisions of the Law.
15.3 However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its Shareholders may be
increased only with the unanimous consent of all the Shareholders and in compliance with any other legal requirement.
96356
L
U X E M B O U R G
Chapter V. - Business year
16. Business year.
16.1 The Company’s financial year starts on the first day of January and ends on the last day of December of each year.
16.2 At the end of each financial year, the Company’s accounts, as well as an inventory indicating the value of the
Company’s assets and liabilities, are established by the Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of
Managers.
16.3 Each Shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
17. Distribution right of shares
17.1 From the annual net profit of the Company, five per cent shall be deducted and allocated to a legal reserve. That
deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal reserve reaches one tenth of the Company's share
capital.
17.2 The Shareholders determine how the balance of the annual net profits is disposed of. It may allocate such balance
to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward.
17.3 The decision to distribute dividends and the determination of the amount of such a distribution will be taken by
the general meeting of the Shareholders.
17.4 The Board of Managers or the Sole Manager may, within the limits set forth by the Law and the Articles, decide
to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the Board of Managers or the Sole Manager
showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not
exceed realized profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable reserves,
but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these
Articles.
Chapter VI. - Liquidation
18. Causes of dissolution. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights,
insolvency or bankruptcy of the single Shareholder or of one of the Shareholders.
19. Liquidation.
19.1 The liquidation of the Company can only be decided if approved by a majority of the Shareholders representing
at least three-quarters of the Company’s share capital.
19.2 The liquidation will be carried out by one or several liquidators, Shareholders or not, appointed by the Share-
holders who shall determine their powers and remuneration.
19.3 A sole Shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally
the payment of all its assets and liabilities, known or unknown of the Company.
Chapter VII. - Applicable law
20. Applicable law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is
made in these Articles.
21. Severability. Should any of the provisions of these Articles be held to be invalid or unenforceable by a body of
competent jurisdiction, such provision shall be replaced by a provision which construes or limits the provision held to
be invalid or unenforceable to the extent necessary to eliminate such invalidity or unenforceability and which shall be as
close as possible to the original intention of the provision held to be invalid or unenforceable. The other provisions of
these Articles shall remain in full force and effect.
<i>Third resolutioni>
The Shareholders hereby resolve that Deloitte Audit, société à responsabilité limitée, with its registered office located
at 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under
the number B. 67.895 shall be appointed as independent auditors of the Company for the forthcoming fiscal year.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a German version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.
WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, he signed together with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung:
Im Jahre zweitausendvierzehn, den zwanzigsten Juni.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, Großherzogtum Luxemburg
96357
L
U X E M B O U R G
ERSCHEINEN
1. Investec GLL SGO REF Holding Alpha S.à r.l., eine nach luxemburgischem Recht gegründete und organisierte Ge-
sellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit Sitz in 15, Rue Bender, L-1229 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg, im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister ("RCS") eingetragen unter der Nummer
B 136.469, zum gegenwärtigen Zeitpunkt Inhaber von zweihundertachtzehn (218) Anteilen an der Gesellschaft;
hier ordnungsgemäß vertreten durch Henri DA CRUZ, Privatbeamter, geschäftsansässig in Junglinster, aufgrund einer
Vollmacht vom 18. Juni 2014, und
2. GLL Management Company S.à r.l., eine nach luxemburgischem Recht gegründete und organisierte Gesellschaft mit
beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit Sitz in 15, Rue Bender, L-1229 Luxemburg, Großherzogtum
Luxemburg, im RCS eingetragen unter der Nummer B 116.672, im eigenen Namen und handelnd für GLL Retail Center
I, FCP-FIS, welcher in der Form eines fonds commun de placement - fonds d'investissement spécialisé gemäß dem Lu-
xemburger Gesetz vom 13. Februar 2007 über Spezialisierte Investmentfonds, in seiner aktuellen Fassung, aufgelegt wurde
und zum gegenwärtigen Zeitpunkt Inhaber von zweihundertzweiundachtzig Anteilen (282) an der Gesellschaft ist;
hier ordnungsgemäß vertreten durch Henri DA CRUZ, Privatbeamer, geschäftsansässig in Junglinster, aufgrund einer
Vollmacht vom 18. Juni 2014.
Die Vollmachten, die vom Bevollmächtigten der Erschienenen sowie dem unterzeichneten Notar mit ne varietur un-
terzeichnet werden, bleiben der vorliegenden Urkunde dauerhaft beigefügt, und werden zusammen und zeitgleich mit
dieser Urkunde bei den jeweiligen Registerstellen eingereicht.
Die Erschienenen sind die Gesellschafter ("Gesellschafter") der Gesellschaft "Retkauf III S.à r.l.", einer Gesellschaft mit
beschränkter Haftung (société a responsabilité limitée), mit Gesellschaftssitz in 6A, route de Trèves, L-2633 Senninger-
berg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im RCS unter Nummer B 123225, gegründet durch eine von Maître Joseph
Elvinger am 19. Dezember 2006 errichtete und 7. März 2007 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
Nummer 287, Seite 13749 veröffentlichte Urkunde ("Gesellschaft"). Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt am 14.
Februar 2013 gemäß einer von Maître Paul Bettingen, Notar mit Amtssitz in Niederanven, Großherzogtum Luxemburg,
errichteten und am 12. April 2013 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 873, Seite 41860
veröffentlichten Urkunde geändert.
Die Erschienenen, die das gesamte Gesellschaftskapital vertreten, fassen hiermit die folgenden Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Gesellschafter beschließen hiermit, den Sitz der Gesellschaft von 6A, Route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Großherzogtum Luxemburg nach 15, rue Bender, L-1229 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg zu verlegen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Gesellschafter beschliessen, die Satzung der Gesellschaft, die künftig lautet wie folgt, hiermit zu ändern und voll-
ständig zu neu fassen:
Kapitel I. - Rechtsform, Firma, Sitz, Gegenstand und Dauer
1. Rechtsform, Firma der Gesellschaft.
1.1 Die Gesellschaft besteht in der Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (private limited liability
company) nach luxemburgischem Recht mit der Firma "Retkauf III S.à r.l." (nachstehend "Gesellschaft"), für die diejenigen
rechtlichen Bestimmungen gelten, die auf eine solche Gesellschaft Anwendung finden, insbesondere das Gesetz über
Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 in der jeweils geltenden Fassung (nachstehend "Gesetz über Handelsgesell-
schaften") und die vorliegende Satzung (nachstehend "Satzung").
2. Sitz.
2.1 Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt.
2.2 Der Sitz der Gesellschaft kann durch einen Beschluss der außerordentlichen Versammlung der Gesellschafter (wie
nachstehend definiert), der in der für Änderungen der Satzung vorgesehenen Weise gefasst wurde, an einen beliebig
anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.
2.3 Allerdings ist der Alleiniger Geschäftsführer (wie nachstehend definiert), bzw. bei Vorhandensein mehrerer Ge-
schäftsführer, die Geschäftsführung (wie nachstehend definiert) befugt, den Sitz der Gesellschaft innerhalb der Stadt
Luxemburg zu verlegen.
2.4 Sofern eine militärische, politische, wirtschaftliche oder soziale Situation eintritt oder offenbar unmittelbar be-
vorsteht, die die gewöhnliche Geschäftstätigkeit am Sitz der Gesellschaft verhindern würde, kann der Sitz der Gesellschaft
vorübergehend ins Ausland verlegt werden, bis sich die Situation normalisiert hat. Eine solche vorübergehende Maßnahme
hat jedoch keine Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die eine luxemburgische Gesellschaft bleibt. Die
Entscheidung über die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft ins Ausland trifft der Alleinige Geschäftsführer (wie nach-
stehend definiert), bzw. bei Vorhandensein mehrerer Geschäftsführer, die Geschäftsführung (wie nachstehend definiert).
96358
L
U X E M B O U R G
3. Gesellschaftszweck.
3.1 Der Zweck der Gesellschaft besteht darin, Wertpapiere anderer Unternehmen (mit oder ohne eigene Rechts-
persönlichkeit), die über Immobilien in Luxemburg oder im Ausland verfügen, (unmittelbar oder mittelbar) zu erwerben,
zu finanzieren, zu halten und zu tauschen oder zu veräußern, beispielsweise durch Zeichnung oder Erwerb von Wertpa-
pieren und Rechten durch Beteiligung, Einlage, Übernahme einer Emission, Kauf oder Option, Begebung oder in sonstiger
Weise, und entsprechende Portfolios zu verwalten, auszubauen und damit zu wirtschaften.
3.2 Die Gesellschaft kann den Unternehmen, an denen sie unmittelbare oder mittelbare Beteiligungen hält, oder die
Teil derselben Unternehmensgruppe sind wie die Gesellschaft selbst, Schuldinstrumente in beliebiger Form, beispielsweise
Darlehen und Wertpapiergarantien zur Verfügung stellen. Die Gesellschaft kann Anleihen, Schuldverschreibungen oder
vergleichbare Schuldtitel in beliebiger Art oder Weise ausleihen bzw. im Rahmen von Privatplatzierungen ausgeben (issue
privately).
3.3 Die Gesellschaft kann ihre Mittel außerdem zum Erwerb, zur Erweiterung, zur Veräußerung, Bewirtschaftung und/
oder zur Vermietung von Immobilien im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland, sowie für andere Geschäfte mit
Bezug zu Immobilien verwenden.
3.4 Die Gesellschaft kann zudem Geschäfte in den Bereichen Wirtschaft, Industrie, Finanzen, Mobilien und Immobilien
machen, wenn diese in unmittelbaren oder mittelbaren Zusammenhang mit ihrem Gesellschaftszweck stehen, oder ihrer
Einschätzung zur Erreichung oder Förderung ihrer Zwecke sinnvoll sind.
4. Dauer des Bestehens. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet.
Kapitel II. - Kapital, Anteile
5. Stammkapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) und besteht aus zwölftausendfünf-
hundert Anteilen (12.500) mit einem Nennbetrag von jeweils einem Euro (EUR 1) (nachstehend "Anteil" bzw. "Anteile").
Inhaber der Anteile werden jeweils auch als "Gesellschafter" bezeichnet.
5.2 Zusätzlich zum Gesellschaftskapital kann ein Aufgeldkonto (das "Aufgeldkonto") eingerichtet werden, auf das An-
teilsaufgelder oder andere Einlagen überwiesen werden, die geleistet werden, ohne dass eine Ausgabe von Anteilen erfolgt.
Der Betrag auf dem Aufgeldkonto steht dem (oder den) Gesellschafter(n) zur freien Verfügung. Der Betrag auf dem
Aufgeldkonto kann verwendet werden, um Zahlungen auf Anteile zu leisten, die die Gesellschaft gegebenenfalls von ihrem
(oder ihren) Gesellschafter(n) zurücknimmt, um realisierte Nettoverluste auszugleichen, um Ausschüttungen an den (oder
die) Gesellschafter vorzunehmen, oder um ihn in die gesetzlichen Rücklagen einzustellen.
5.3 Alle Anteile sind mit den gleichen Rechten verbunden.
5.4 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Aktien innerhalb der vom Gesetz über Handelsgesellschaften vorgesehenen
Grenzen zurückkaufen.
6. Unteilbarkeit der Anteile. Im Verhältnis zur Gesellschaft sind die Anteile unteilbar, so dass nur ein Inhaber pro Anteil
zugelassen ist. Miteigentümer haben eine einzige Person als Vertreter gegenüber der Gesellschaft zu bestimmen.
7. Übertragung von Anteilen.
7.1 Eine Übertragung von Anteilen ist grundsätzlich nur an eine Gesellschaft zulässig.
7.2 Vorkaufsrecht
(a) Innerhalb von 18 Monaten ab dem 20. Juni 2014 können die Anteile übertragen werden, und zwar nur an einen
Geeigneten Empfänger (wie nachstehend definiert); jeder Gesellschafter hat ein Vorkaufsrecht bezüglich der Anteile des
anderen Gesellschafters.
(b) Ein Geeigneter Empfänger ist ein institutioneller Anleger, der über ausreichende finanzielle Ressourcen verfügt, um
allen Verpflichtungen nachzukommen, die aus seiner Position als Gesellschafter entstehen ("Geeigneter Empfänger"). Der
Nachweis der Finanzlage des Geeigneten Empfängers erfolgt durch dessen Jahresabschlüsse und Umsätze für die drei
letzten Geschäftsjahre und/oder geeignete finanzielle Garantien.
(c) Wenn ein Gesellschafter beabsichtigt, ein verbindliches Angebot über den Verkauf seiner Anteile gegenüber einem
Geeigneten Empfänger abzugeben ("Anbieter"), oder wenn er ein verbindliches Angebot über den Erwerb seiner Anteile
von einem Geeigneten Empfänger erhält, und der Anbieter entscheidet, diese Anteile zu verkaufen, wird er zunächst ein
schriftliches Angebot ("Angebot") über den Verkauf der Anteile an den anderen Gesellschafter ("Angebotsempfänger")
zu denselben Konditionen abgeben, zu denen er beabsichtigt, an den Geeigneten Empfänger zu verkaufen. Das Angebot
enthält alle konkreten und detaillierten Informationen zum geplanten Verkauf seitens des Anbieters an den Geeigneten
Empfänger.
(d) Wenn der Angebotsempfänger beabsichtigt, das Angebot anzunehmen, teilt er dies dem Anbieter innerhalb von
fünfundvierzig (45) Tagen nach dem Zugang des Angebots mit. Der Kaufvertrag zwischen dem Anbieter und dem Ange-
botsempfänger über alle Anteile, auf die sich das Angebot bezieht, kommt zustande, wenn die schriftliche Mitteilung des
Angebotsempfänger über die Annahme des Angebots dem Anbieter zugeht; ein Kaufvertrag über eine geringere Zahl von
Anteilen kann auf diesem Wege nicht abgeschlossen werden.
96359
L
U X E M B O U R G
(e) Wenn der Angebotsempfänger nicht innerhalb von fünfundvierzig (45) Tagen nach dem Zugang des Angebots beim
Angebotsempfänger mitteilt, dass er beabsichtigt, die Anteile zu erwerben, gilt dies als Ablehnung des Angebots und
Nichtausübung des Vorkaufsrechts durch den Angebotsempfänger.
(f) Wenn die in Ziffer 7.2(d) genannte Frist von fünfundvierzig (45) Tagen abläuft, ohne dass der Angebotsempfänger
seine Absicht zum Kauf der Anteile zum Ausdruck bringt, ist der Anbieter berechtigt, alle Anteile, auf die sich das Angebot
an den Geeigneten Empfänger bezieht, zu Konditionen an den Geeigneten Empfänger zu verkaufen, die nicht günstiger
sein dürfen als die Konditionen des Angebots; ein Kaufvertrag über eine geringere Zahl von Anteilen kann auf diesem
Wege nicht abgeschlossen werden.
(g) Der Angebotsempfänger kann ein Mitglied seines Konzerns zur Ausübung des Vorkaufsrechts bestellen. Zur Klar-
stellung wird darauf hingewiesen, dass Tochtergesellschaften der Anteilsinhaber / Gesellschafter des Gesellschafters zum
Konzern (die "Gruppe") im Sinne dieser Ziffer gehören.
7.3 Erstangebotsrecht
(a) Nach Ablauf von 18 Monaten ab dem 20. Juni 2014 hat jeder Gesellschafter gemäß dieser Ziffer 7.3 ein Erstange-
botsrecht bezüglich der Anteile des anderen Gesellschafters.
(b) Wenn der Anbieter beabsichtigt, ein unverbindliches Angebot über den Verkauf seiner Anteile gegenüber einem
potenziell interessierten Dritten ("Potenzieller Käufer") abzugeben, oder wenn er ein unverbindliches Angebot über den
Erwerb seiner Anteile von einem Potenziellen Käufer erhält, und der Anbieter entscheidet, diese Anteile zu verkaufen,
wird er zunächst ein Angebot über den Verkauf der Anteile an den Angebotsempfänger zu denselben Konditionen ab-
geben, zu denen er beabsichtigt, an den Potenziellen Käufer zu verkaufen. Das Angebot enthält lediglich Angaben zur
Gesamtzahl der zum Verkauf stehenden Anteile und zum Kaufpreis im Falle eines Verkaufs des Anbieters an den Po-
tenziellen Käufer.
(c) Wenn der Angebotsempfänger beabsichtigt, das Angebot anzunehmen, teilt er dies dem Anbieter innerhalb von
fünfundvierzig (45) Tagen nach dem Zugang des Angebots mit. Der Kaufvertrag zwischen dem Anbieter und dem Ange-
botsempfänger über alle Anteile, auf die sich das Angebot bezieht, kommt zustande, wenn die schriftliche Mitteilung des
Angebotsempfänger über die Annahme des Angebots dem Anbieter zugeht; ein Kaufvertrag über eine geringere Zahl von
Anteilen kann auf diesem Wege nicht abgeschlossen werden.
(d) Wenn der Angebotsempfänger nicht innerhalb von fünfundvierzig (45) Tagen nach dem Zugang des Angebots beim
Angebotsempfänger mitteilt, dass er beabsichtigt, die Anteile zu erwerben, gilt dies als Ablehnung des Angebots und
Nichtausübung des Erstangebotsrechts durch den Angebotsempfänger.
(e) Wenn die in Ziffer 7.3(d) genannte Frist von fünfundvierzig (45) Tagen abläuft, ohne dass der Angebotsempfänger
seine Absicht zum Kauf der Anteile zum Ausdruck bringt, ist der Anbieter für einen Zeitraum von sechs (6) Monaten
nach dem Zugang des Angebots beim Angebotsempfänger berechtigt, alle Anteile, auf die sich das Angebot an den Po-
tenziellen Käufer bezieht, zum Preis von mindestens 95 % des im Angebot genannten Kaufpreises und zu Konditionen,
die nicht günstiger sein dürfen als die Konditionen des Angebots an den Potenziellen Käufer (oder einen Dritten) zu
verkaufen; ein Kaufvertrag über eine geringere Zahl von Anteilen kann auf diesem Wege nicht abgeschlossen werden.
(f) Der Angebotsempfänger kann ein Mitglied seines Konzerns zur Ausübung des Erstangebotsrechts bestellen. Zur
Klarstellung wird darauf hingewiesen, dass Tochtergesellschaften der Anteilsinhaber / Gesellschafter des Gesellschafters
zum Konzern im Sinne dieser Ziffer gehören.
7.4 Konzerninterne Übertragung
(a) Ein Gesellschafter kann seine Anteile frei an ein Mitglied seines jeweiligen Konzerns übertragen. Zur Klarstellung
wird darauf hingewiesen, dass Tochtergesellschaften der Anteilsinhaber / Gesellschafter des Gesellschafters zum Konzern
im Sinne dieser Ziffer gehören.
(b) Im Falle einer Übertragung der Anteile eines Gesellschafters auf ein Konzernmitglied des betreffenden Gesell-
schafters ("Neuer Gesellschafter"), verpflichtet sich der übertragende Gesellschafter ("Zedent") zur Gewährung unmit-
telbarer Sicherheiten gegenüber dem anderen Gesellschafter im Hinblick auf die Verpflichtungen eines Neuen
Gesellschafters gemäß dieser Satzung.
(c) Der Zedent und der Neue Gesellschafter werden den anderen Gesellschafter darüber in Kenntnis setzen, wenn
der Neue Gesellschafter aus dem Konzern des Zedenten ausscheidet; der Zedent wird die betreffenden Anteile vom
Neuen Gesellschafter erwerben (bzw. die Anteile sind auf den Zedenten zurück zu übertragen, jeweils unmittelbar bevor
der Neue Gesellschafter aus dem Konzern des Zedenten ausscheidet). Verträge über die Übertragung von Anteilen an
ein Mitglied des Konzern des Gesellschafters sollen wirksame und durchsetzbare Bestimmungen enthalten, wonach der
Zedent solche Anteile vom Neuen Gesellschafter zurück erwirbt und der Neue Gesellschafter verpflichtet ist, die Anteile
an den Zedenten zu veräußern und auf diesen zurück zu übertragen, wenn der Neue Gesellschafter den Konzern des
Zedenten verlässt. Eine Übertragung von Anteilen auf ein Mitglied des Konzerns des Zedenten kann nur erfolgen, wenn
und soweit der Zedent gegenüber den anderen Gesellschaftern nachweist, dass er die Verpflichtungen gemäß dieser Ziffer
7.4 vollumfänglich erfüllt hat. Jeder Gesellschafter soll dem anderen Gesellschafter die entsprechenden Informationen
überlassen, die dieser in angemessener Weise benötigt, um festzustellen, ob der Neue Gesellschafter noch Mitglied des
Konzerns des Zedenten ist.
96360
L
U X E M B O U R G
Kapitel III. - Management
8. Geschäftsführung.
8.1 Die Gesellschaft wird von einem Geschäftsführer (der "Alleinige Geschäftsführer") oder mehreren Geschäftsfüh-
rern verwaltet. Falls mehrere Geschäftsführer ernannt wurden, besteht der Geschäftsführerrat aus diesen Geschäftsfüh-
rern (zusammen, der "Geschäftsführerrat", jeder Geschäftsführer einzeln, ein "Geschäftsführer"). Es ist nicht erforderlich
dass der Alleinige Geschäftsführer oder die Mitglieder des Geschäftsführerrates, gegebenenfalls, Gesellschafter sind.
8.2 Der Alleinige Geschäftsführer oder die Mitglieder des Geschäftsführerrates können jederzeit durch eine Entschei-
dung der außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschafter, die im Einklang mit Kapitel IV getroffen wurde,
abberufen werden.
8.3 Der Alleinige Geschäftsführer oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, der Geschäftsführerrat ist
befugt, alle Entscheidungen zu treffen, welche in Zusammenhang mit der Geschäftsführung der Gesellschaft stehen, solange
dies gemäß Artikel 12 erfolgt.
8.4 Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten vom Alleinigen Geschäftsführer, und im Falle einer Mehrzahl von Ge-
schäftsführern von je zwei Geschäftsführern vertreten und wirksam verpflichtet und dies im Einklang mit Artikel 10 der
Satzung, und gemäß Artikel 191 bis Absatz 5 des Gesetzes sind jede Urkunde, jeder Vertrag oder generell jedes Dokument,
welches in Überstimmung mit Artikel 8 und 10 der hiesigen Satzung unterzeichnet wurden, Dritten gegenüber wirksam
und bindend. Die Ausübung der Vertretungsmacht durch zwei Geschäftsführer benötigt keine vorherige Zustimmung
vom einvernehmlich handelnden Geschäftsführerrat.
8.5 Die Geschäftsführer dürfen nicht, aufgrund ihres Mandates, persönlich für etwaige gültig von Ihnen im Namen der
Gesellschaft abgeschlossene Verpflichtungen haftbar gemacht werden, vorausgesetzt diese Verpflichtungen entsprechen
der Satzung und dem Gesetz.
Unbeschadet des vorstehenden Absatzes, beträgt die Verjährungsfrist etwaiger Klagen der Gesellschaft gegen einem
Geschäftsführer ein Jahr, es sei denn es wurde eine Entscheidung von den Gesellschaftern im Einklang mit Artikel 13.9
vor dem Verfall der einjährigen Verjährungsfrist getroffen, um den Geschäftsführer, oder im Falle einer Mehrzahl von
Geschäftsführern den Geschäftsführerrat, aus seiner Haftung zu entlassen, wobei die Vollstreckbarkeit von Klagen gegen
die Geschäftsführer im Augenblick der Entlastung durch die Gesellschafter endet.
8.6 Der Alleinige Geschäftsführer, oder im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern der Geschäftsführerrat, wird
von einem Beirat unterstützt.
Der Beirat besteht aus bis zu 10 Mitgliedern formell ernannt vom Geschäftsführer oder, in Falle einer Mehrzahl von
Geschäftsführern dem Geschäftsführerrat (die "Mitglieder des Beirats" oder einzeln das "Mitglied des Beirats").
Die Mitglieder des Beirats werden durch eine transparente, die indirekte Beteiligung der Endinvestoren der Gesell-
schafter bestimmende, Prozedur festgelegt (die "Endinvestoren") (die "Indirekte Beteiligung"). Zum Zweck der Festlegung
der Indirekten Beteiligung, werden die Gesellschafter in Bezug auf das Vertretungsrecht im Beirat als transparent be-
trachtet.
Die Indirekte Beteiligung wird gemäß der folgenden Formel berechnet:
IB = G x B
Wobei:
IB = Indirekte Beteiligung
G = % der Beteiligung des jeweiligen Gesellschafters in der Gesellschaft
B = % der Beteiligung des Endinvestoren im jeweiligen Gesellschafter
Endinvestoren deren Indirekte Beteiligung 10.00% überschreitet, haben das Recht einen Vertreter in den Beirat zu
entsenden. Um jeden Zweifel auszuschließen, darf kein Endinvestor mehr als einen Vertreter im Beirat ernennen, unge-
achtet der Größe seiner Indirekten Beteiligung. Die Wahlrechte der Mitglieder des Beirats stehen den Indirekten
Beteiligungen der Endinvestoren gleich.
Es wird kein Quorum für die Sitzungen des Beirats geben, obwohl die wichtigen Entscheidungen, wie sie unter a-f
dieser Klausel 8.6 genannt werden, die Zustimmung von 60% der bestehenden Wahlrechten des Beirats benötigen. Falls
die verlangte Mehrheit von 60% der bestehenden Wahlrechte nicht erreicht wird, wird eine zweite Sitzung des Beirats
innerhalb von 20 Geschäftstagen einberufen um die vorgestellte Frage wieder zu besprechen, basierend auf weiteren zur
Verfügung gestellten Informationen und Dokumenten.
Falls die verlangte Mehrheit von 60% der bestehenden Wahlrechte des Beirats nicht in der zweiten Sitzung erreicht
wird, gilt es das Verfahren der Klausel 8.7 anzuwenden.
Der Beirat wird vorwiegend in Luxemburg zusammenkommen. Der Beirat wird auf Einladung des Alleinigen Ge-
schäftsführers oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, des Geschäftsführerrates, des Vorsitzenden des Beirats
oder einem Mitglied des Beirats zusammenkommen und tritt mindestens einmal im Jahr zusammen.
Die Mitglieder des Beirats stimmen entweder schriftlich ab oder halten ihre Sitzungen per Telefon oder persönlich ab,
nachdem eine Einberufung unter Angabe der Gegenstände der Tagesordnung mit einer Frist von mindestens fünf (5)
Bankarbeitstagen erfolgt ist (es sei denn jedes Mitglied des Beirats hat schriftlich darauf verzichtet).
96361
L
U X E M B O U R G
Stimmt der Beirat nicht schriftlich ab, wird das Protokoll der Versammlung des Beirats vom Vorsitzenden des Beirats
unterzeichnet.
Mitglieder des Beirats können Bevollmächtigte ernennen, um im Rahmen des anwendbaren Rechts Sitzungen beizu-
wohnen.
Der Beirat wird dem Alleinigen Geschäftsführer oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, dem Geschäfts-
führerrat, seine vorherige Zustimmung erteilen, bevor der Geschäftsführerrat über einen der folgenden Punkte für die
Gesellschaft entscheidet:
a) Potentielle neue Investitionen mit Ausnahme der Investitionen in die Gesellschaft;
b) Verkauf von Vermögenswerten;
c) an ihn durch den Alleinigen Geschäftsführer oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, dem Geschäfts-
führerrat, herangetragene Interessenkonflikte;
d) spezielle Angelegenheiten die, nach Entscheidung der Hauptversammlung der Gesellschafter, dem Beirat zur Ge-
nehmigung vorgelegt werden soll;
e) die Verpfändung oder Belastung des Eigentums oder eines Grundstückes, das von der Gesellschaft gehalten wird,
außer der ursprünglichen Verpfändung oder Belastung im Zusammenhang mit dem Kauf der Gesellschaft durch die Ge-
sellschafter oder solche Verpfändung oder Belastung, die für den Kauf der Gesellschaft durch die Gesellschafter nötig sein
könnte.
f) Finanzierung oder überschüssige Refinanzierung der Finanzierung der Gesellschafter im Zusammenhang mit dem
Kauf der Gesellschaft durch die Gesellschafter und back-to-back Finanzierung durch Gesellschafterdarlehen gewährt
durch die Gesellschafter (einschließlich Investec GLL Special Opportunities Real Estate Fund, FCP-FIS) an die Gesellschaft.
8.7 Ein durch den Beirat zustimmungsbedürftiges Drag Along Ereignis gilt im Hinblick auf die unter Klausel 8.6 b)
genannten Angelegenheiten als eingetreten, sobald:
i. Der Verkauf von Kapitalanlagen durch den Ablauf der Lebensdauer von GLL Retail Center I, FCP-FIS oder Investec
GLL Global Special Opportunities Real Estate Fund (die "Fonds") erforderlich ist, und
ii. Der (die) Fond(s) seine (ihre) Lebensdauer nicht verkürzt hat (haben), oder
iii. Die zweite Versammlung des Beirats keine 60% Mehrheit der abgegebenen Stimmen des Beirats im Hinblick auf die
Abstimmung über den Verkauf der jeweiligen Vermögenswerte erreicht hat.
(a) Ein Drag Along Ereignis wie unter den hier oben stehenden Punkten i.-iii. kann nicht vor dem 29. Mai 2017 eintreten.
Die Gesellschafter sind verpflichtet, sich mindestens ein Mal innerhalb des Monats nach der zweiten Versammlung zu
treffen, um das Drag Along Ereignis zu verhandeln. Falls das Drag Along Ereignis nicht vom Beirat binnen eines Monats
nach der zweiten Versammlung aufgelöst werden kann, wie unter 8.6 beschrieben (welches, um jeden Zweifel auszu-
schließen, im Falle einer Ablehnung des Beirats zur Zustimmung das Datum der Versammlung des Beirats ist oder das
Datum der Umlaufbeschlüsse des Beirats, welche das Mehrheitserfordernis aus Klausel 8.6 nicht erfüllen (sollte der
Umlaufbeschluss aus mehreren getrennten Dokumenten bestehen, so soll das Datum des letzten eingereichten Beschlus-
ses entscheidend sein)), so soll der Alleinige Geschäftsführer oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, der
Geschäftsführerrat, den Wert der Anteile bestimmen. Zu diesem Zweck soll der Alleinige Geschäftsführer oder, im Falle
einer Mehrzahl von Geschäftsführern, der Geschäftsführerrat, einen Marktwert der Anlageobjekte der Gesellschaft
("Marktwert") beschaffen. Der Alleinige Geschäftsführer oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, der Ge-
schäftsführerrat, soll dem Beirat eine Liste von mindestens drei fachkundigen, unabhängigen und seriösen externen
Gutachtern (zusammen die "Unabhängigen Gutachter" oder einzeln der "Unabhängige Gutachter") vorschlagen. Sollte
der Beirat einen einzelnen Gutachter mit einer Mehrheit von 60% der abgegebenen Stimmen ernennen, ist dieser Gut-
achter vom Alleinigen Geschäftsführer oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, dem Geschäftsführerrat,
befugt den Marktwert und somit auch den (Endgültigen) Drag Along Preis zu bestimmen. Sollte der Beirat keinen einzelnen
Unabhängigen Gutachter ernennen, so soll der Alleinige Geschäftsführer oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäfts-
führern, der Geschäftsführerrat, drei Unabhängige Gutachter beauftragen, um den Wert der Vermögensgegenstände mit
dem Durchschnitt der drei Gutachten zu bestimmen und diesen für die Bestimmung des Marktwertes und des Drag Along
Preises zu benutzen.
(b) Die Bewertung der Anteile erfolgt mittels der folgenden Formel und soll den Drag Along Preis der Anteile der
Gesellschaft bestimmen, der von den Unabhängigen Gutachtern erstellt wird (die "Drag Along Preise"):
- Das letzte IFRS Kapital angepasst an den Cash-Flow der Tätigkeiten, aber ohne die Gewinne/Verluste der Verfügungen
und nicht amortisierenden Akquisitionskosten
- abzüglich des Buchwerts der Anlageimmobilien
- zuzüglich des Marktwerts
- abzüglich Ausschüttungen von realisierten Verfügungen
- abzüglich Verfügungen und Liquidationskosten der Gesellschaft
(c) Nach der Bestimmung der Drag Along Preise und falls drei Unabhängige Gutachter ernannt worden sind, werden
die von den Unabhängigen Gutachtern aufgestellten Drag Along Preise vom Alleinigen Geschäftsführer oder, im Falle
einer Mehrzahl von Geschäftsführern, vom Geschäftsführerrat verglichen und sollten eventuelle Abweichungen unter den
96362
L
U X E M B O U R G
ermittelten Drag Along Preisen weniger als 10.00% betragen, so soll der Endgültige Drag Along Preis der Durchschnitts-
wert aus allen drei Drag Along Preisen, wie sie von den Unabhängigen Gutachtern bestimmten worden sind, sein.
(d) Sollte die Abweichung zwischen den von den Unabhängigen Gutachtern bestimmten Drag Along Preisen mehr als
10.00% betragen, hat der Alleinige Geschäftsführer oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, der Geschäfts-
führerrat, einen vierten Unabhängigen Gutachter zu ernennen (der "Vierte Unabhängige Gutachter"), der festlegt, welcher
von den Unabhängigen Gutachtern bestimmte Drag Along Preis seiner eigenen Wertung des Drag Along Preises am
Nähesten kommt. Gemäß der Beurteilung des Vierten Unabhängigen Gutachters soll dieser Drag Along Preis der End-
gültige Drag Along Preis sein.
(e) Der Gesellschafter, für den das Drag Along Ereignis gemäß a. vorstehend bestätigt wird (der "Erste Gesellschafter")
kann dem anderen Gesellschafter (dem "Zweiten Gesellschafter") ein schriftliches Angebot vorlegen (die "Angebotsmit-
teilung"), welche einen Transfer der von dem Ersten Gesellschafter zur Zeit gehaltenen Anteile (die "Erstverkauf Anteile")
für den Endgültigen Drag Along Preis an den Zweiten Gesellschafter anbietet. Der Zweite Gesellschafter kann die An-
gebotsmitteilung annehmen oder einem Mitglied seiner Gruppe anheimstellen die Erstverkauf Anteile zu erwerben. Aus
Gründen der Klarheit, umfasst die Gruppe für den Zweck dieser Klausel auch etwaige Tochtergesellschaften der Gesell-
schafter der Gesellschafter.
(f) Der Erste Gesellschafter soll eine Kopie der Angebotsmitteilung an die Gesellschaft schicken, zeitgleich zu der
Angebotsmitteilung die an den Zweiten Gesellschafter geschickt wird.
(g) Der Zweite Gesellschafter oder das jeweilig ernannte Gruppenmitglied soll dem Ersten Gesellschafter schriftlich
binnen 20 Geschäftstagen ab Zugang der Angebotsmitteilung mitteilen, ob er die Erstverkauf Anteile gemäß der Bedin-
gungen der Angebotsmitteilung zu erwerben beabsichtigt.
(h) Sollte Zweite Gesellschafter oder das jeweilig ernannte Gruppenmitglied den Ersten Gesellschafter von seinem
Willen die Erstverkauf Anteile nach den Bedingungen der Angebotsmitteilung zu erwerben informieren, so ist der Erste
Gesellschafter verpflichtet, dem Zweiten Gesellschafter oder dem jeweilig ernannten Gruppenmitglied die Erstverkauf
Anteile zum Endgültigen Drag Along Preis zu verkaufen. Der Zweite Gesellschafter oder das jeweilig ernannte Gruppen-
mitglied haben binnen 20 Tagen ab der schriftlichen Kundgabe ihres Erwerbswillens an den Ersten Gesellschafter, dem
Ersten Gesellschafter den in der Angebotsmitteilung übermittelten Preis für die Erstverkauf Anteile zu zahlen und der
Erste Gesellschafter soll binnen 15 Geschäftstagen ab Eingang des Endgültigen Drag Along Preises dem Zweiten Gesell-
schafter oder dem jeweilig ernannten Gruppenmitglied den ordnungsgemäß ausgeführten Übergang zugunsten des
Zweiten Gesellschafters sowie den (die) Anteilsurkunde(n) der Erstverkauf Anteile zuzustellen. Der Endgültige Drag
Along Preis soll einer Post-Abschluss Preis-Anpassung unterliegen, welche auf einem geprüften IFRS Abschlussbericht
basiert.
(i) Falls der Zweite Gesellschafter dem Ersten Gesellschafter schriftlich mitteilt, die Erstverkauf Anteile nach den
Bedingungen der Angebotsmitteilung nicht erwerben zu wollen ("Negative Bekanntmachung"), beginnt die Ausgangspro-
zedur, welche das Joint Venture Agreement vorsieht, das zwischen den Gesellschaftern und Investec GLL Fund
Management Company S.A. in eigenem Namen aber für Investec GLL Global Special Opportunities Real Estate Fund
handelnd besteht ("Joint Venture Agreement").
(j) Sollte nach Ablauf der oben genannten 20 Geschäftstage der Zweite Gesellschafter noch keine schriftliche Be-
kanntmachung wie sie unter (h) vorgesehen ist an den Ersten Gesellschafter kommuniziert haben, wird der Zweite
Gesellschafter angesehen als hätte er die Angebotsmitteilung des Ersten Gesellschafters abgelehnt und die Ausgangspro-
zedur, welche das Joint Venture Agreement vorsieht, wird in Gang gesetzt.
9. Befugnisse des Geschäftsführers oder des Geschäftsführerrats.
9.1 Im Umgang mit Dritten, hat der Alleinige Geschäftsführer, oder im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, der
Geschäftsführerrat, unbeschadet der Artikel 8 bis 10 dieser Satzung alle Befugnisse, um die Gesellschaft in allen Umständen
zu vertreten und alle Geschäfte und andere Unternehmen die dem Objekt der Gesellschaft entsprechen zu verrichten.
9.2 Alle Befugnisse, welche nicht gesetzlich oder durch die Satzung der Hauptversammlung der Gesellschafter vorbe-
halten sind, fallen in die Zuständigkeit des Alleinigen Geschäftsführers, oder im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern,
des Geschäftsführerrats.
10. Vertretung der Gesellschaft. Gegenüber Dritten, wird die Gesellschaft unter allen Umständen (i) durch die Un-
terschrift des Alleinigen Geschäftsführers; (ii) im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, durch die gemeinsame
Unterschrift von jeweils zwei Geschäftsführern; oder, (iii) den Umständen entsprechend, durch die gemeinsame oder
einzelne Unterschrift(en) (einer) etwaigen Person(en) der (denen) solch eine Unterschriftsvollmacht gültig im Einklang
mit der Satzung delegiert wurde, verpflichtet sein.
11. Bevollmächtigung und bevollmächtigte des alleinigen Geschäftsführere oder des Geschäfstführerrats.
11.1 Der alleinige Geschäftsführer oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, jeweils zwei Geschäftsführer,
können ihre Befugnisse für bestimmte Aufgaben jeweils auf einen oder mehrere Ad-Hoc Bevollmächtigte übertragen.
11.2 Der alleinige Geschäftsführer oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, jeweils zwei Geschäftsführer,
werden die Verpflichtungen und Vergütung (falls anwendbar), die Dauer der Vertretung sowie sonstige wesentliche Be-
dingungen der Bevollmächtigung bestimmen.
96363
L
U X E M B O U R G
12. Geschäftsführerversammlung.
12.1 Im Falle eines Geschäftsführerrats, werden die Geschäftsführerversammlungen von jeweils einem Geschäftsführer
an einem im Einberufungsschreiben angegebenen Ort einberufen. Schriftliche Ankündigung (einschließlich durch Email)
jeder Geschäftsführerversammlung muss jedem Gesellschaftsführer mindestens achtundvierzig (48) Stunden im Voraus
kommuniziert werden, außer in dringenden Fällen, welche im Einberufungsschreiben darzulegen sind.
12.2 Sind alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten und diese geben diese an volle Kenntnis der Tagesordnung
zu besitzen, kann auf die Einberufung verzichtet werden. Auf Einberufung einer Versammlung kann von den Geschäfts-
führern ebenfalls schriftlich (einschließlich durch Email) verzichtet werden, sei es vor oder nach der Versammlung. Es
werden keine separaten Einberufungsschreiben für Versammlungen benötigt, die an Zeiten und Orten abgehalten werden,
welche in einem vorher verabschiedeten Anhang vom Geschäftsführerrat angegeben wurden, oder in einer vorherigen
Versammlung bestimmt wurden und im Versammlungsprotokoll niedergeschrieben wurden.
12.3 Jeder Gesellschafter darf in jeder Versammlung des Geschäftsführerrats agieren indem er einen anderen Ge-
schäftsführer schriftlich oder durch Telegramm, Fax, Email oder Brief als seinen Bevollmächtigten ernennt. Ein Geschäfts-
führer mag ebenfalls über Telefon einen anderen Geschäftsführer als seinen Bevollmächtigten ernennen, solange dies an
einem späteren Zeitpunkt schriftlich bestätigt wird.
12.4 Der Geschäftsführerrat bestimmt aus dem Kreis seiner Mitglieder einen Vorsitzenden (der "Vorsitzende"). Der
Vorsitzende wird jede Versammlung des Geschäftsführerrats präsidieren. In seiner Abwesenheit oder seiner Handlungs-
unfähigkeit mögen die anwesenden Geschäftsführer einen unter ihnen als Vorsitzenden der jeweiligen Versammlung
ernennen (der pro tempore Vorsitzende).
12.5 Der Geschäftsführerrat kann nur gültig beraten und agieren falls eine Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder
vertreten ist. Die Beschlüsse des Geschäftsführerrats sind gültig, falls sie von der Mehrheit seiner Mitglieder gefasst
wurden.
12.6 Das Benutzen von Videokonferenzgeräten und Telefonkonferenzen ist erlaubt, falls diese es jedem teilnehmenden
Geschäftsführer erlauben die alle andere teilnehmende Geschäftsführer zu hören und von ihnen gehört zu werden, ob
diese von dieser Technologie Gebrauch machen oder nicht, und jeder so teilnehmende Geschäftsführer werden als
anwesend betrachtet und sei die Erlaubnis besitzen per Video oder Telefon abzustimmen.
12.7 Ein schriftlicher Beschluss ist ordnungsgemäß und rechtskräftig, wenn er von allen Mitgliedern des Geschäftsfüh-
rerrats unterzeichnet wurde. Ein solcher Beschluss kann aus einem oder mehreren ähnlichen Dokumenten bestehen, die
per Fax, per Email oder ähnlichen Mitteln. Diese Beschlüsse stehen einem Beschluss, der in einer ordnungsgemäß einbe-
rufenen sowie abgehaltenen Geschäftsführerratsversammlung gefasst wurde, gleich. Schriftliche Beschlüsse werden
rechtswirksam am Tag der letzten Unterschrift eines Geschäftsführers oder, im Falle von partiell oder vollständig unda-
tierten Unterschriften, am Eingangsdatum der letzten unterschriebenen Beschlüsse am eingetragenen Sitz der Gesellschaft.
12.8 Stimmen können über Fax, Email, Telefon oder ähnliche Mittel abgegeben werden, wenn diese Abstimmung später
in Schriftform bestätigt wird. Das im Einklang mit der Satzung unterschriebene und das Abstimmungsthema dokumen-
tierende Protokoll gilt als schriftliche Bestätigung.
12.9 Das Protokoll der Geschäftsführerversammlung ist vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit, vom pro
tempore Vorsitzenden der Versammlung, oder mindestens von zwei in der Versammlung anwesenden oder vertretenen
Mitgliedern des Geschäftsführerrats zu unterschreiben. Auszüge hiervon können von einem Geschäftsführer oder einer
Person, die hiervon von einem Geschäftsführer oder während der Versammlung bevollmächtigt wurden, beurkundet
werden.
12.10 Im Falle eines Alleinigen Geschäftsführers, können die Beschlüsse des Alleinigen Geschäftsführers schriftlich
dokumentiert werden.
Kapitel IV. - Hauptversammlung der Gesellschafter
13. Befugnisse der Hauptversammlung, Einberufung und Abhärtung von Versammlungen - Abstimmungen
13.1 Beschlüsse der Gesellschafter werden im Rahmen einer Gesellschafterversammlung (die "Hauptversammlung")
oder im Umlaufverfahren gefasst (die "Umlaufbeschlüsse ").
13.2 Sollen Umlaufbeschlüsse gefassst werden, wird der Wortlaut der Beschlüsse in satzungsgemäßer Weise an alle
Gesellschafter versandt. Umlaufbeschlüsse, die von allen Gesellschaftern unterzeichnet sind, erlangen die gleiche Gültig-
keit und Rechtskraft wie im Rahmen einer ordnungsgemäß einberufenen Hauptversammlung gefasste Beschlüsse zum
Datum der zuletzt geleisteten Unterschrift.
13.3 Jeder Anteil gewährt eine Stimme.
13.4 Die Gesellschafter werden auf Veranlassung eines Managers oder von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des
Stammkapitals repräsentieren, zu Hauptversammlungen einbestellt oder um schriftliche Stellungnahmen gebeten.
13.5 Die schriftliche (auch per E-Mail) Mitteilung über eine Hauptversammlung an die Gesellschafter erfolgt mindestens
fünf (5) Tage vor der Hauptversammlung, es sei denn es liegt ein Notfall vor, dessen Art und Umstände in der Mitteilung
näher genannt werden.
13.6 Hauptversammlungen werden an dem Ort und zu dem Zeitpunkt abgehalten, die in der Einladung näher angegeben
sind.
96364
L
U X E M B O U R G
13.7 Wenn sämtliche Gesellschafter anwesend oder ordnungsgemäß vertreten sind und sich als ordnungsgemäß ein-
geladen und über die Tagesordnung der Versammlung ausreichend informiert ansehen, kann die Gesellschafterversamm-
lung ohne vorherige Mitteilung einberufen werden.
13.8 Ein Gesellschafter kann eine anderen Person, gleich ob diese Gesellschafter ist oder nicht, schriftlich bevollmäch-
tigen, ihn bei der Hauptversammlung zu vertreten.
13.9 Unabhängig von der Anzahl der Gesellschafter sind die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung den Gesell-
schaftern zur Genehmigung vorzulegen, die ebenfalls separat darüber abstimmen sollen, ob dem alleinigen Geschäftsführer
oder, bei mehreren Geschäftsführern, der Geschäftsführung, Entlastung zu erteilen ist.
14. Alleiniger Gesellschafter.
14.1 Wenn es nur einen (1) Gesellschafter gibt, kommen dem alleinigen Gesellschafter sämtliche Befugnisse zu, die
das Gesetz über Handelsgesellschaften der Hauptversammlung verleiht.
14.2 Ein Verweis in der Satzung auf die Gesellschafter und die Gesellschafterversammlung oder Umlaufbeschlüsse sind
als Verweis auf diesen alleinigen Gesellschafter bzw. dessen Beschlüsse zu lesen.
14.3 Die Beschlüsse des Alleinigen Gesellschafters werden in einem Protokoll festgehalten oder schriftlich niedergelegt.
15. Mehrheiten.
15.1 Gemeinschaftliche Entscheidungen gelten nur dann als wirksam getroffen, wenn sie von Gesellschaftern genehmigt
werden, die mehr als die Hälfte des Stammkapitals halten. Wird diese Zahl bei der ersten Versammlung oder der ersten
schriftlichen Beratung nicht erreicht, wird durch Einschreiben an die Gesellschafter eine zweite Sitzung oder Beratung
einberufen, und Entscheidungen werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, ungeachtet des durch
diese jeweils vertretenen Kapitals.
15.2 Beschlüsse über Satzungsänderungen können nur mit einer zahlenmäßigen Mehrheit von Gesellschaftern mit
Eigentum an mehr als drei Viertel des Stammkapitals der Gesellschaft in Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes
über Handelsgesellschaften gefasst werden.
15.3 Eine Änderung der Nationalität der Gesellschaft oder eine Erhöhung der Zahl der Gesellschafter kann allerdings
nur einvernehmlich durch alle Gesellschafter und unter Einhaltung aller anderen rechtlichen Erfordernisse beschlossen
werden.
Kapitel V. - Geschäftsjahr.
16. Geschäftsjahr.
16.1 Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Tag des Monats Januar und endet am letzten Tag des Monats
Dezember eines jeden Jahres.
16.2 Am Ende eines jeden Geschäftsjahrs erstellt der alleinige Geschäftsführer bzw. bei Vorhandensein mehrerer
Geschäftsführer, die Geschäftsführung, den Jahresabschluss der Gesellschaft sowie ein Verzeichnis mit dem Wert der
Aktiva und Passiva der Gesellschaft.
16.3 Jeder Gesellschafter hat das Recht, das obige Verzeichnis und die Bilanz am Sitz der Gesellschaft einzusehen.
17. Ausschüttung des Gewinns.
17.1 Vom Nettogewinn der Gesellschaft, welcher in Übereinstimmung mit den anwendbaren rechtlichen Bestimmun-
gen ermittelt wurde, werden fünf Prozent (5%) zur Bildung der gesetzlichen Rücklage verwendet. Diese zwingende
Verpflichtung zur Bildung der Rücklage endet, wenn diese Rücklage einen Betrag erreicht hat, der einem Zehntel des
Gesellschaftskapitals entspricht.
17.2 Die Gesellschafter beschließen darüber, wie der Differenzbetrag des jährlichen Nettogewinns zu verwenden ist.
Sie können einen solchen Differenzbetrag ausschütten, in die Rücklagen einstellen oder zum Gewinnvortrag nutzen.
17.3 Die Entscheidung, Dividenden auszuschütten und die Festlegung des Betrags einer solchen Ausschüttung erfolgt
durch die Gesellschafterversammlung.
17.4 Die Geschäftsführung oder der alleinige Geschäftsführer kann, soweit das Gesetz über Handelsgesellschaften und
die Satzung dies erlaubt, auf der Grundlage des von der Geschäftsführung oder dem alleinigen Geschäftsführer erstellten
Jahresabschlusses, dem zu entnehmen ist, dass hinreichend Finanzmittel für eine Ausschüttung zur Verfügung stehen, eine
Zwischenausschüttung beschließen, wobei zu beachten ist, dass der Ausschüttungsbetrag die seit dem Ende des letzten
Geschäftsjahres erzielten Gewinne nicht überschreiten darf, erhöht um Gewinne aus Überträgen und ausschüttungsfä-
higen Rücklagen, jedoch abzüglich von Verlustvorträgen und Summen, die aufgrund Gesetzes oder dieser Satzung in die
Rücklagen einzustellen sind.
Kapitel VI. - Liquidation
18. Auflösungsgründe. Die Gesellschaft wird wegen Todes, Außerkraftsetzung von Bürgerrechten, Insolvenz oder
Bankrott des alleinigen Gesellschafters oder von einem der Gesellschafter nicht aufgelöst.
96365
L
U X E M B O U R G
19. Liquidation.
19.1 Die Liquidation der Gesellschaft kann nur beschlossen werden, wenn sie von einer Mehrheit der Gesellschafter
genehmigt wird, die mindestens drei Viertel des Stammkapitals der Gesellschaft vertreten.
19.2 Die Liquidation erfolgt durch einen oder mehrere Abwickler (liquidateur), Gesellschafter oder nicht, die von der
Hauptversammlung der Gesellschafter bestellt werden, die auch dessen bzw. deren Befugnisse und Vergütung festlegen.
19.3 Ein alleiniger Gesellschafter kann die Auflösung der Gesellschaft beschließen und ihre Liquidation veranlassen,
indem er persönlich alle bekannten und unbekannten Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft über-
nimmt.
Kapitel VII. - Geltendes recht
20. Geltendes recht. Für sämtliche Angelegenheiten, die in dieser Satzung nicht gesondert geregelt sind, wird auf die
Bestimmungen des Gesetzes über Handelsgesellschaften verwiesen.
21. Teilunwirksamkeit. Wird eine in dieser Satzung enthaltene Bestimmung von einer zuständigen Instanz für unwirk-
sam oder nicht durchsetzbar gehalten, ist diese Bestimmung durch eine Bestimmung zu ersetzen, die die für unwirksam
oder nicht durchsetzbar gehaltene Bestimmung auslegt oder einschränkt, soweit dies erforderlich ist, um die Unwirk-
samkeit oder mangelnde Durchsetzbarkeit zu beseitigen und die der ursprünglichen mit der für unwirksam oder nicht
durchsetzbar gehaltenen Bestimmung verfolgten Absicht am nächsten kommt. Die anderen Bestimmungen dieser Satzung
bleiben vollumfänglich wirksam.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Gesellschafter beschließen hiermit, dass Deloitte Luxembourg als unabhängiger Abschlussprüfer der Gesellschaft
für das kommende Geschäftsjahr bestellt wird.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar, der Englisch spricht und versteht, erklärt hiermit, dass diese Urkunde auf Wunsch der
obigen Parteien in englischer Sprache verfasst ist, und dem englischen Text eine deutsche Version folgt. Auf Wunsch
derselben erschienenen Parteien hat im Falle von Widersprüchen zwischen dem englischen und dem deutschen Text die
englische Version Vorrang.
DARAUFHIN wurde die vorliegende Urkunde an dem eingangs genannten Tag in Luxemburg errichtet.
Nach Verlesen dieser Urkunde gegenüber dem Erschienenen, hat dieser gemeinsam mit dem Notar die vorliegende
Urkunde unterzeichnet.
Gezeichnet: Henri DA CRUZ, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 30 juin 2014. Relation GRE/2014/2563. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2014096405/922.
(140114100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2014.
Azul Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 197.270.369,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 131.006.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
In the year two thousand and fourteen, on the nineteenth day of May.
Before Us, Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Azul Holding S.C.A., a partnership limited by shares (société en commandite par actions) established and existing under
the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B
131319 (hereinafter referred to as the Sole Shareholder),
here represented by Ms. Sofia Da Chao Conde, employee, with professional address at 5, rue Zénon Bernard, L-4030
Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given on May 16, 2014.
The said proxy, signed ne varietur by the proxy holder of the appearing person and the undersigned notary, will remain
attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing person, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing person is the Sole Shareholder of the private limited liability company (société à responsabilité limitée)
established and existing in the Grand-Duchy of Luxembourg under the name Azul Finance S.à r.l., (hereinafter referred
96366
L
U X E M B O U R G
to as the Company), with registered office at 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand Duchy of Lu-
xembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 131006, established
pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, dated July
25, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, dated October 5, 2007, under number 2206,
and whose articles of association have been last amended pursuant to a deed of the undersigned notary dated May 13,
2014 and not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
It is reminded that, on May 13, 2014, the Company’s Sole Shareholder has decided to anticipatively dissolve and to
put the Company into liquidation and to appoint itself as liquidator of the Company (the Liquidator).
Pursuant to the Sole Shareholder resolutions dated May 13, 2014, the Sole Shareholder resolved to appoint Headstart
Management Services S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) established and existing
under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 7, rue Robert Stümper, L-2557 Lu-
xembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under
number B 155181, as liquidation auditor of the Company (the Liquidation Auditor).
II. The Company’s share capital is set at one hundred ninety-seven million two hundred seventy thousand three hundred
sixty-nine Euro (EUR 197.270.369,00) represented by one hundred ninety-seven million two hundred seventy thousand
three hundred sixty-nine (197.270.369) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each.
III. The Sole Shareholder resolves to take the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to approve the liquidation accounts of the Company as at May 19, 2014.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to acknowledge the Liquidator’s report. The said report, signed ne varietur by the
proxyholder of the person appearing, will remain annexed to the present resolutions.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to acknowledge the Liquidation Auditor’s report. The said report, signed ne varietur
by the proxyholder of the person appearing, will remain annexed to the present resolutions.
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to close the liquidation of the Company.
<i>Fifth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to give mandate to the Liquidator of the Company for the follow-up of the provisions
and the operations to be done after the closing of the liquidation.
<i>Sixth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to grant discharge to the Liquidator and to the Liquidation Auditor for the exercise of
their mandates.
<i>Seventh resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to deposit and keep the Company’s books at the registered office of the Company for
a period of five (5) years starting at the date hereof, and resolve that all the sums and assets eventually belonging to
creditors who were not present at the end of the liquidation will be deposed at the same former registered office.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxy holder of
the above appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same
person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the date first written above.
The document having been read to the proxy holder of the appearing person, who is known to the notary by her full
name, civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille quatorze, le dix-neuf mai.
Par-devant Nous, Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
Azul Holding S.C.A., une société en commandite par actions, établie et existante selon les lois du Grand-Duché de
Luxembourg, ayant son siège social au 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
96367
L
U X E M B O U R G
et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 131319 (ci-après
l’Associé Unique),
ici représentée par Mme Sofia Da Chao Conde, employée, ayant son adresse professionnelle au 5, rue Zénon Bernard,
L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé le 12 mai
2014., employé, ayant son adresse professionnelle au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée sous seing privé le 16 mai 2014.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumentaire,
demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.
La comparante, représentée par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter que:
I. La comparante est l’associé unique de la société à responsabilité limitée établie dans le Grand-Duché de Luxembourg
sous la dénomination Azul Finance S.à r.l., (ci-après, la Société), ayant son siège social au 2, Avenue Charles de Gaulle,
L-1653 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg, sous le numéro B 131006, constituée par acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, en date du 25 juillet 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en
date du 5 octobre 2007, sous le numéro 2206, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire
soussigné en date du 13 mai 2014, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Il est rappelé que le 13 mai 2014, l’Associé Unique de la Société a décidé de dissoudre avec anticipation la Société et
de la mettre en liquidation et de se nommer en tant que liquidateur de la Société (le Liquidateur).
En vertu des résolutions de l’Associé Unique en date du 13 mai 2014, l’Associé Unique a décidé de nommer Headstart
Management Services S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 7,
rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 155181, en tant que commissaire à la liquidation de la Société (le
Commissaire à la Liquidation).
II. Le capital social de la Société est fixé à cent quatre-vingt-dix-sept millions deux cent soixante-dix mille trois cent
soixante-neuf Euro (EUR 197.270.369,00) représenté par cent quatre-vingt-dix-sept millions deux cent soixante-dix mille
trois cent soixante-neuf (197.270.369) parts sociales d’une valeur nominale d’un Euro (EUR 1,00) chacune.
III. L’Associé Unique décide de prendre les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Associé Unique décide d’approuver les comptes de liquidation de la Société au 19 mai 2014.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Associé Unique a pris connaissance du rapport du Liquidateur. Ledit rapport, signé ne varietur par le mandataire du
comparant, demeurera annexé aux présentes.
<i>Troisième résolutioni>
L’Associé Unique a pris connaissance du rapport du Commissaire à la Liquidation. Ledit rapport, signé ne varietur par
le mandataire du comparant, demeurera annexé aux présentes.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Associé Unique décide de clôturer la liquidation de la Société.
<i>Cinquième résolutioni>
L’Associé Unique décide de donner mandat au Liquidateur de la Société pour le suivi des provisions et les opérations
à effectuer après la clôture de la liquidation.
<i>Sixième résolutioni>
L’Associé Unique décide de donner décharge au Liquidateur et au Commissaire à la Liquidation pour l’exercice de
leurs mandats.
<i>Septième résolutioni>
L’Associé Unique décide de déposer et conserver les livres de la Société au siège social de la Société pour une période
de cinq (5) ans débutant à la date des présentes et décident que toutes sommes et actifs éventuellement dû à des créanciers
qui n’étaient pas présents à la fin de la liquidation seront également déposés au siège social de la Société.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête du mandataire de la
personne comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française. A la requête de cette même
personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
DONT PROCES-VERBAL, fait et passé à Esch-sur-Alzette, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
96368
L
U X E M B O U R G
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la personne comparante, connue du notaire par son nom et
prénom, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire, le présent acte.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 22 mai 2014. Relation: EAC/2014/7181. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Santioni.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2014075294/131.
(140088539) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2014.
Capula ESS Lux 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 7, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 177.365.
In the year two thousand and fourteen, on the thirteenth day of May,
Before Maître Joëlle Baden, notary, residing in Luxembourg,
There appeared:
Capula European Special Situations Fund L.P., an exempted limited partnership incorporated and existing under the
laws of the Cayman Islands, having its registered office at PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman
Islands, registered with the Registrar of Exempted Limited Partnerships under number MC-70819,
represented by its general partner, Capula European Special Situations Fund (GP) L.P., an exempted limited partnership
incorporated and existing under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at PO Box 309, Ugland House,
Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands, registered with the Registrar of Exempted Limited Partnerships under number
MC-70808,
represented by its general partner, Capula European Special Situations Fund (GP) Limited, a limited company incor-
porated and existing under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at PO Box 309, Ugland House,
Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands, registered with the Registrar of Companies under number MC-274461,
duly represented by Ms Fouzia Benyahia , Maître en droit, having her professional address in Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given on 9
th
May 2014 in Lugano.
The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to
this deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party is the sole member of Capula ESS Lux 1 S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its
registered office at 7, Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, recorded with the Luxembourg Trade and Com-
panies' Register under number B 177.365, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on 2 May 2013,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1620 on 6 July 2013 (hereafter the "Company").
The Articles were amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary on 3 March 2014, not yet
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
The appearing party, representing the entire share capital, requested the undersigned notary to act that the agenda of
the meeting is as follows:
<i>Agendai>
1. Increase of the share capital of the Company from its current amount of one million two hundred thousand one
hundred twenty-five euro (EUR 1,200,125.-), represented by one hundred and nine thousand one hundred and three
(109,103) class A shares and one million ninety-one thousand twenty-two (1,091,022) class B shares, having a par value
of one euro (EUR 1.-) each, up to one million seven hundred thousand one hundred twenty-five euro (EUR 1,700,125.-),
through the issue of forty-five thousand four hundred and fifty-five (45,455) new class A shares and four hundred and
fifty-four thousand five hundred and forty-five (454,545) new class B shares, having a par value of one euro (EUR 1.-) each,
against a payment in cash;
2. Subsequent amendment of Article 5.1 of the articles of association of the Company.
The appearing party, representing the entire share capital, took the following resolutions:
<i>First resolution:i>
The sole member resolves to increase the share capital of the Company from its current amount of one million two
hundred thousand one hundred twenty-five euro (EUR 1,200,125.-), represented by one hundred and nine thousand one
hundred and three (109,103) class A shares and one million ninety-one thousand twenty-two (1,091,022) class B shares,
having a par value of one euro (EUR 1.-) each, up to one million seven hundred thousand one hundred twenty-five euro
(EUR 1,700,125.-), through the issue of forty-five thousand four hundred and fifty-five (45,455) new class A shares and
four hundred and fifty-four thousand five hundred and forty-five (454,545) new class B shares, having a par value of one
euro (EUR 1.-) each.
96369
L
U X E M B O U R G
<i>Subscription:i>
The forty-five thousand four hundred and fifty-five (45,455) new class A shares and four hundred and fifty-four thousand
five hundred and forty-five (454,545) new class B shares have been subscribed by Capula European Special Situations Fund
L.P., aforementioned, at a total price of five hundred thousand euro (EUR 500,000.-) entirely allocated to the share capital.
The forty-five thousand four hundred and fifty-five (45,455) new class A shares and four hundred and fifty-four thousand
five hundred and forty-five (454,545) new class B shares have been fully paid up in cash by Capula European Special
Situations Fund L.P., aforementioned, and the total amount of five hundred thousand euro (EUR 500,000.-) is at the
disposal of the Company, as it has been shown to the undersigned notary.
<i>Second resolution:i>
As a consequence of the above resolution, the sole member resolves to amend Article 5.1 of the articles of association
of the Company which shall henceforth read as follows:
“ 5.1. The Company's share capital is set at one million seven hundred thousand one hundred twenty-five euro (EUR
1,700,125.-), consisting of:
- one hundred and fifty-four thousand five hundred and fifty-eight (154,558) class A shares, having a par value of one
euro (EUR 1.-) each (the “Class A Shares”); and
- one million five hundred and forty-five thousand five hundred and sixty-seven (1,545,567) class B shares, having a par
value of one euro (EUR 1.-) each (the “Class B Shares”, and together with the Class A Shares, the “Shares”).”
There being no further business, the meeting is closed.
Whereof, this deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that upon request of the proxyholder
of the appearing person, this deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the same appearing
proxyholder of the appearing person and in case of divergences between the English and the French texts, the English
version will be prevailing.
The document having been read to the proxyholder of the above appearing party known to the notary, such person
signed together with the notary this deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille quatorze, le treize mai,
Par devant Maître Joëlle Baden, notaire, résidant à Luxembourg,
A comparu:
Capula European Special Situations Fund L.P., un exempted limited partnership, constitué et existant sous les lois des
Iles Caïmans, ayant son siège social à PO Box 309, Ugland House, Grand Caïman, KY1-1104, Iles Caïmans, immatriculé
auprès du Registrar of Exempted Limited Partnerships sous le numéro MC-70819,
représenté par son gérant commandité, Capula European Special Situations Fund (GP) L.P, un exempted limited part-
nership, constitué et existant sous les lois des Iles Caïmans, ayant son siège social à PO Box 309, Ugland House, Grand
Caïman, KY1-1104, Iles Caïmans, immatriculé auprès du Registrar of Exempted Limited Partnerships sous le numéro
MC-70808,
représenté par son gérant commandité, Capula European Special Situations Fund (GP) Limited, une société à respon-
sabilité limitée (limited company), constituée et existant sous les lois des Iles Caïmans, ayant son siège social à PO Box
309, Ugland House, Grand Caïman, KY1-1104, Iles Caïmans, immatriculé auprès du Registrar of Companies sous le
numéro MC-274461,
dûment représenté par Madame Fouzia Benyahia, Maître en droit, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg,
Grand-duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 9 mai 2014 à Lugano.
Ladite procuration, signée "ne varietur" par le mandataire du comparant et par le notaire soussigné, restera annexée
au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Le comparant est l'associé unique de Capula ESS Lux 1 S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège
social au 7, Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 177.365, constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 2 mai 2013, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1620 du 6 juillet 2013 (ci-après la "Société"). Les statuts ont
été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire soussigné en date du 3 mars 2014, non encore publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations.
Le comparant, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire soussigné de prendre acte que l'ordre du
jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Agendai>
1. Augmentation du capital social de la Société de son montant actuel d'un million deux cent mille cent vingt-cinq euros
(1.200.125,-) représenté par cent neuf mille cent trois (109.103) parts sociales de catégorie A et un million quatre-vingt-
96370
L
U X E M B O U R G
onze mille vingt-deux (1.091.022) parts sociales de catégorie B, d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, au
montant d'un million sept cent mille cent vingt-cinq euros (EUR 1.700.125,-) par l'émission de quarante-cinq mille quatre
cent cinquante-cinq (45.455) nouvelles parts sociales de catégorie A et quatre cent cinquante-quatre mille cinq cent
quarante-cinq (454.545) nouvelles parts sociales de catégorie B d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, en
échange d'un paiement en numéraire;
2. Modification subséquente de l'article 5.1 des statuts de la Société.
Le comparant, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolution:i>
L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société de son montant actuel d'un million deux cent mille
cent vingt-cinq euros (1.200.125,-) représenté par cent neuf mille cent trois (109.103) parts sociales de catégorie A et
un million quatre-vingt-onze mille vingt-deux (1.091.022) parts sociales de catégorie B, d'une valeur nominale d'un euro
(EUR 1,-) chacune, au montant d'un million sept cent mille cent vingt-cinq euros (EUR 1.700.125,-) par l'émission de
quarante-cinq mille quatre cent cinquante-cinq (45.455) nouvelles parts sociales de catégorie A et quatre cent cinquante-
quatre mille cinq cent quarante-cinq (454.545) nouvelles parts sociales de catégorie B d'une valeur nominale d'un euro
(EUR 1,-) chacune.
<i>Souscription:i>
Les quarante-cinq mille quatre cent cinquante-cinq (45.455) nouvelles parts sociales de catégorie A et quatre cent
cinquante-quatre mille cinq cent quarante-cinq (454.545) nouvelles parts sociales de catégorie B ont été souscrites par
Capula European Special Situations Fund L.P., susmentionné, pour un montant de cinq cent mille euros (EUR 500.000,-)
intégralement alloué au capital social.
Les quarante-cinq mille quatre cent cinquante-cinq (45.455) nouvelles parts sociales de catégorie A et quatre cent
cinquante-quatre mille cinq cent quarante-cinq (454.545) nouvelles parts sociales de catégorie B ainsi souscrites ont été
entièrement libérées en numéraire par Capula European Special Situations Fund L.P., susmentionné, et le montant total
de cinq cent mille euros (EUR 500.000,-) est à la libre disposition de la Société tel qu'il a été démontré au notaire soussigné.
<i>Seconde résolution:i>
A la suite de la résolution précédente, l'associé unique a décidé de modifier l'article 5.1 des statuts de la Société, qui
aura désormais la teneur suivante:
« 5.1. La Société a un capital social d'un million sept cent mille cent vingt-cinq euros (EUR 1.700.125,-) représenté par:
- cent cinquante-quatre mille cinq cent cinquante-huit (154.558) parts sociales de catégorie A ayant une valeur nominale
d'un euro (EUR 1,-) chacune (les «Parts Sociales A»); et par
- un million cinq cent quarante-cinq mille cinq cent soixante-sept (1.545.567) parts sociales de catégorie B ayant une
valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune (les «Parts Sociales B» et ensemble avec les Parts Sociales A, les «Parts
Sociales»).»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du mandataire du comparant, le présent
acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du mandataire de ce même comparant et en
cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire instrumentant par nom,
prénom usuel, état et demeure, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: F. BENYAHIA et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 15 mai 2014. LAC / 2014 / 22585. Reçu soixante quinze euros € 75,-.
<i>Le Receveuri> (signé): THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.
Luxembourg, le 28 mai 2014.
Référence de publication: 2014075391/150.
(140088860) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2014.
Bateman Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 86.189.
In the year two thousand fourteen, on the twentieth day of the month of May;
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;
96371
L
U X E M B O U R G
Is held
an extraordinary general meeting (the “Meeting”) of the shareholders of “BATEMAN LUXEMBOURG S.A.”, a public
limited company (“société anonyme”) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, established and having
its registered office in L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll, registered with the Trade and Companies Registry
of Luxembourg, section B, under number 86189, (the”Company”), incorporated pursuant to a deed of Me Paul BET-
TINGEN, notary residing in Niederanven (Grand Duchy of Luxembourg), on February 7, 2002, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, number 847 of June 4, 2002,
and whose articles of association of the Company (the “Articles”) have been amended several times and for the last
time pursuant to a deed of Me Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), on
December 19, 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 546 of March 6, 2013.
The Meeting is presided by Mr. Christian FRANCOIS, employee, residing professionally in L-2086 Luxembourg, 412F,
route d'Esch.
The Chairman appointed as secretary Mrs. Angèle COMMODI, employee, residing professionally in L-2086 Luxem-
bourg, 412F, route d'Esch, and the Meeting elected as scrutineer Mr. Renaud LEONARD, employee, residing professionally
in L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
The board of the Meeting having thus been constituted, the Chairman has declared and requested the officiating notary
to state:
A) That the agenda of the Meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1) Decision to proceed with the company's liquidation;
2) Appointment of one or several liquidator(s) and specification of his (or their) powers;
3) Discharge of the directors of the company and of the statutory auditor;
4) Miscellaneous.
B) That the shareholders, present or represented, as well as the number of their shares held by them, are shown on
an attendance list; this attendance list is signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders, the
members of the board of the Meeting and the officiating notary.
C) That the proxies of the represented shareholders, signed “ne varietur” by the members of the board of the Meeting
and the officiating notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.
D) That the whole corporate capital being present or represented at the present Meeting and that all the shareholders,
present or represented, declare having had due notice and got knowledge of the agenda prior to this Meeting and waiving
to the usual formalities of the convocation, no other convening notice was necessary.
E) That the present Meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deli-
berate on all the items on the agenda.
Then the Meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:
<i>First resolution:i>
The Meeting decides, with immediate effect, to proceed with the anticipated dissolution of the company and to put it
into voluntary liquidation.
<i>Second resolution:i>
The Meeting appoints “Bateman Engineering Management B.V.”, a private limited liability company existing under the
law of the Netherlands, with legal address in NL-3072 AP Rotterdam, “Maastoren”, Wilhelminakade 91, registered with
the Chamber of Commerce (“Kamer van Koophandel”) under number 34250374, as liquidator.
The liquidator has the most extended powers as provided by articles 144 to 148bis of the Luxembourg companies
law. He may carry out all the deeds provided by article 145 without previous general meeting authorization if required
by law.
All powers are granted to the liquidator to represent the company for all operation being a matter of liquidation
purpose to realize the assets, to discharge all liabilities and to distribute the net assets of the company to the shareholders
in proportion to their shareholding, in kind or in cash.
The said person may in particular, without the following enumeration being limitative, sell, exchange and alienate all
either movable or immovable properties and all related rights, and alienate the said property or properties if the case
arises, grant release with waiver of all chattels, charges, mortgages and actions for rescission, of all registrations, entries,
garnishments and attachments, absolve the registrar of mortgages from automatic registration, accord all priorities of
mortgages and of charges, concede priorities of registration, make all payments even if they are not ordinary administrative
payments, remit all debts, compound and compromise on all matters of interest to the Company, extend all jurisdictions,
and renounce remedies at law or acquired rights of prescription.
96372
L
U X E M B O U R G
<i>Third resolution:i>
The Meeting decides to give full discharge to the directors and the statutory auditor of the Company for the accom-
plishment of their mandate for the period from July 1
st
, 2013 until the date of the present Meeting.
No further item being on the agenda of the Meeting and nobody asking to speak, the Chairman then adjourned the
Meeting.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately evaluated at one thousand seven
hundred Euros.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above
appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
persons, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the appearing persons, known to the notary by their name, first name, civil status
and residence, the said appearing persons have signed together with Us, the notary, the present deed.
Suit la version en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille quatorze, le vingtième jour du mois de mai;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné;
S'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'“Assemblée”) de “BATEMAN LUXEMBOURG S.A.”, une so-
ciété anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1882 Luxembourg,
12F, rue Guillaume Kroll, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro
86189, (la “Société”), constituée suivant acte reçu par Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven
(Grand-Duché de Luxembourg), le 7 février 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
847 du 4 juin 2002,
et dont les statuts (les “Statuts”) ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte re4u par
Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 19 décembre 2012,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 546 du 6 mars 2013.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Christian FRANCOIS, employé, demeurant professionnellement
à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Angèle COMMODI, employée, demeurant professionnellement à
L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch, et l'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Renaud LEONARD, em-
ployé, demeurant professionnellement à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:
A) Que la présente Assemblée a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Décision de la dissolution anticipée et de la mise en liquidation de la société.
2. Nomination de liquidateur(s) et détermination de ses (leurs) pouvoirs.
3. Décharge donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Divers.
B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre de actions possédées par chacun d'eux, sont
portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux
représentés, les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant.
C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées “ne varietur” par les membres du bureau de l'Assemblée
et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.
D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés,
déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette Assemblée et
renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.
E) Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.
Ensuite l'Assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
96373
L
U X E M B O U R G
<i>Première résolution:i>
L'Assemblée décide la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation volontaire.
<i>Deuxième résolution:i>
L'Assemblée nomme “Bateman Engineering Management B.V.”, une société à responsabilité limitée existant sous les
lois des Pays-Bas, ayant son siège social à NL-3072 AP Rotterdam, “Maastoren”, Wilhelminakade 91, inscrite auprès de
la Chambre de Commerce (“Kamer van Koophandel”) sous le numéro 34250374, comme liquidateur.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés
commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale
dans les cas où elle est requise.
Pouvoir est conféré au liquidateur de représenter la société pour toutes opérations pouvant relever des besoins de
la liquidation, de réaliser l'actif, d'apurer le passif et de distribuer les avoirs nets de la société aux actionnaires, propor-
tionnellement au nombre de leurs actions, en nature ou en numéraire.
Il peut notamment, et sans que l'énumération qui va suivre soit limitative, vendre, échanger et aliéner tous biens tant
meubles qu'immeubles et tous droits y relatifs; donner mainlevée, avec renonciation à tous droits réels, privilèges, hy-
pothèques et actions résolutoires, de toutes inscriptions, transcriptions, mentions, saisies et oppositions; dispenser le
conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; accorder toutes priorités d'hypothèques et de privilèges;
céder tous rangs d'inscription; faire tous paiements, même s'ils n'étaient pas de paiements ordinaires d'administration;
remettre toutes dettes; transiger et compromettre sur tous intérêts sociaux; proroger toutes juridictions; renoncer aux
voies de recours ou à des prescriptions acquises.
<i>Troisième résolution:i>
L'Assemblée décide de donner décharge aux administrateurs et au commissaire des comptes de la Société, pour la
période allant du 1
er
juillet 2013 jusqu'à la date de la présente Assemblée.
Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'Assemblée et personne ne demandant la parole, le Président a
ensuite clôturé l'Assemblée.
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à mille sept cents euros.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête des com-
parants le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes comparants, et en cas
de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits
comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: C. FRANCOIS, A. COMMODI, R. LEONARD, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 22 mai 2014. LAC/2014/23648. Reçu douze euros 12,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
Luxembourg, le 28 mai 2014.
Référence de publication: 2014075361/156.
(140089362) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2014.
Dialogiques, Société Anonyme.
Siège social: L-4210 Esch-sur-Alzette, 69, rue de la Libération.
R.C.S. Luxembourg B 59.514.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2014075454/11.
(140088803) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2014.
96374
L
U X E M B O U R G
Bugy Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Bugy Capital S.à r.l., SPF).
Capital social: EUR 2.639.489,16.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 165.619.
L'an deux mille quatorze, le quinze mai.
Par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
A COMPARU
«Madame Sylvia GILIS», née le 13 novembre 1972 à Louvain (Belgique), demeurant 11, Knapzak, B-3210 Lubbeek
(Belgique); et,
«Monsieur Vincent Edgard BUSSCHAERT», né le 5 novembre 1964 à Saint-Nicolas (Belgique), demeurant 11, Knapzak,
B-3210 Lubbeek (Belgique),
(Ci-après les «Associés»),
Tous deux représentés par Monsieur Frédéric MANNIS, employé privé, demeurant professionnellement au 20, Bou-
levard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg, en vertu de procurations sous seing privé lui-délivrées.
Lesquelles parties comparantes sont les associés de la Société à responsabilité limitée «Bugy Capital S.à r.l., SPF», ayant
son siège social au 16 Boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg, sous section B numéro 165619, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard LECUIT, notaire
de résidence à Luxembourg en date du 16 décembre 2011, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Asso-
ciations (ci-après le «Mémorial C») numéro 269 du 1
er
février 2010; et dont les statuts ont été modifiés suivant acte
reçu par le notaire soussigné en date du 23 juillet 2013 publié au Mémorial C numéro 2283 du 17 septembre 2013.
Les Associés, agissant en tant que tel, par la présente adoptent, déclarent et demandent au Notaire d’acter les réso-
lutions écrites suivantes:
<i>Résolution uniquei>
Les associés décident de changer l’objet social de la société et de procéder à une refonte complète des statuts qui se
liront désormais comme suit:
« Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-
après la «Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après la «Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après les «Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11
et 15, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations directes ou indirectes et la détention de ces participations,
sous n'importe quelle forme, dans toutes entreprises luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que l’administration, la ges-
tion et la mise en valeur de ces participations.
Ceci inclut, mais n'est pas limité à l’investissement, l’acquisition, la vente, l’octroi ou l’émission de certificats de capital
préférentiels, prêts, obligations, reconnaissances de dettes et autres formes de dettes, parts sociales, bons de souscriptions
et autres instruments de capital ou droits, incluant sans limitation, des parts de capital social, participations dans une
association (limited partnership), participations dans une société à responsabilité limitée (limited liability company), parts
préférentielles, valeurs mobilières et swaps, et toute combinaison de ce qui précède, qu'ils soient facilement réalisables
ou non, ainsi que des engagements (incluant mais non limité à des engagements relatifs à des valeurs synthétiques) de
sociétés, entités ou autres personnes juridiques de tout type.
La Société peut aussi utiliser ses fonds pour investir dans l’immobilier, les droits de propriété intellectuelle ou dans
tout autre actif mobilier ou immobilier de toute sorte ou toute forme.
La Société peut accorder des gages, garanties, privilèges, hypothèques et toute autre forme de sûretés ainsi que toute
forme d'indemnités, à des entités luxembourgeoises ou étrangères, en relation avec ses propres obligations et dettes.
La Société peut accorder toute forme d'assistance (incluant mais non limité à l’octroi d'avances, prêts, dépôts d'argent
et crédits ainsi que l’octroi de gages, garanties, privilèges, hypothèques et toute autre forme de sûretés, de toute sorte
et forme) aux filiales de la Société. De manière plus occasionnelle, la Société peut accorder le même type d'assistance
aux sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société ou à des tiers, sous condition que cela tombe
dans l’intérêt social et sans engendrer une obligation d'une autorisation spécifique.
D'une manière générale, la Société peut effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière et s'engager
dans toute autre activité qu'elle jugera nécessaire, conseillée, appropriée, incidente à ou non contradictoire avec l’ac-
complissement et le développement de ce qui précède.
96375
L
U X E M B O U R G
Nonobstant ce qui précède, la Société ne s'engagera dans aucune transaction qui entraînerait son engagement dans
une quelconque activité qui serait considérée comme une activité réglementée ou qui requerrait de la Société la possession
de toute autre autorisation spécifique.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société aura la dénomination: «Bugy Capital S.à r.l.»
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée
générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.
L’adresse du siège social peut-être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 6. Le capital social est fixé à deux millions six cent trente-neuf mille quatre cent quatre-vingt-neuf euros et seize
centimes d’euros (EUR 2.639.489,16) représenté par quatre cent quatre-vingt-quatre (484) parts sociales d’une valeur
nominale de cinq mille quatre cent cinquante-trois euros et quaranteneuf centimes d’euros (EUR 5.453,49) chacune,
entièrement libérées..
La société peut racheter ses propres parts sociales.
Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être
décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d'achat.
La décision des associés de racheter les parts sociales sera prise par un vote unanime des associés représentant cent pour
cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital social par
annulation des parts sociales rachetées.
Art. 7. Sans préjudice des prescriptions de l’article 6, le capital peut être modifié à tout moment par une décision de
l’associé unique ou par une décision de l’assemblée générale des associés, en conformité avec l’article 15 des présents
Statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec
le nombre des parts sociales existantes.
Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est admis.
Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
La propriété des parts sociales représentant le capital social peut être exercée:
- soit en pleine propriété;
- ou en usufruit par un associé désigné comme «usufruitier» et en nue-propriété par un autre associé désigné comme
«nu-propriétaire».
Dans le cas d'un tel démembrement de la propriété des parts sociales, les prérogatives attachées aux parts sociales
sont définies comme suit:
- l’exercice des droits sociaux, et en particuliers le droit de vote aux assemblées générales, est réservé aux associés
détenteurs de l’usufruit des parts sociales, à l’exclusion des associés détenteurs de la nue-propriété des parts sociales;
- l’exercice des droits de disposition, tels que ces derniers sont déterminés par le droit commun, est réservé aux
associés détenteurs de la nue-propriété des parts sociales à l’exclusion des associés détenteurs de l’usufruit des parts
sociales.
Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-
missibles.
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.
Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de la
faillite de l’associé unique ou d’un des associés.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants.
Si plusieurs gérants qui ne seront pas nécessairement associés sont nommés, ils constitueront le conseil de gérance
(le Conseil). Les associés peuvent décider de nommer des gérants de différentes classes, à savoir un ou plusieurs gérants
de classe A et un ou plusieurs gérants de classe B
Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer
et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.
96376
L
U X E M B O U R G
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
Un gérant pourra délivrer à tout autre gérant, une procuration aux fins de le représenter à tout Conseil de gérance.
Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, si un
ou les associés ont nommé un ou plusieurs gérants de classe A et un ou plusieurs gérants de classe B, au moins un gérant
de classe A et un gérant de classe B est présent ou représenté. Les décisions du Conseil seront valablement prises à la
majorité des voix des gérants présents ou représentés, à la condition qu’un ou les associés ont nommé un ou plusieurs
gérants de classe A et un ou plusieurs gérants de classe B, au moins un gérant de classe A et un gérant de classe B votent
en faveur de la décision. Un tel quorum ne peut être atteint s'il existe une majorité de gérants physiquement présents
dans un pays autre que le Grand-Duché de Luxembourg. Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance,
peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération
(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision
prise à une réunion du conseil de gérance.
Chacun des gérants peut participer à toute réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique (conference-
call), vidéo-conférence ou tout autre moyen de communication similaire permettant à toutes les personnes prenant part
à la réunion d’être en mesure d’entendre les autres participants. La participation à une réunion, par ces moyens, est
équivalente à une participation en personne à cette réunion.
Si les gérants sont temporairement dans l’impossibilité d’agir, la société pourra être gérée par l’associé unique ou en
cas de pluralité d’associés, par les associés agissant conjointement.
Art. 13.
(i) La Société sera engagée par la signature du gérant unique. Si plusieurs gérants sont nommés, la Société sera engagée
par les signatures conjointes de deux gérants ou, si un ou les associés ont nommé un ou plusieurs gérants de classe A et
un ou plusieurs gérants de classe B, par les signatures conjointes d’un gérant de classe A et d’un gérant de classe B.
(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toute(s) personne(s) à qui des pouvoirs
spéciaux ont été délégués par le Conseil.
Art. 14. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 15. L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de
part qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui.
Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant
plus de la moitié du capital.
Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés
détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
Art. 16. L’année sociale commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Art. 17. Chaque année, à la fin de l’année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 18. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortis-
sements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un
fonds de réserve jusqu'à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.
Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la
Société.
Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions prévues
par la Loi.
Art. 19. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés
ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Art. 20. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la
Loi.»
96377
L
U X E M B O U R G
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille deux cent euros (EUR 1.200,-).
Plus rien n'étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, il a signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: F.MANNIS, J.ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils le 19 mai 2014. Relation: LAC/2014/23009. Reçu soixante-quinze euros (EUR
75,-).
<i>Le Receveuri>
(signé): I.THILL.
Référence de publication: 2014075352/171.
(140089286) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2014.
Amigo Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 48, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 146.988.
In the year two thousand fourteen, on 23
rd
May.
Before Maître Blanche MOUTRIER, Notary residing at Esch-sur-Alzette (Grand Duchy of Luxembourg).
Was held
an extraordinary general meeting of the shareholders of “Amigo Luxembourg S.A.” a société anonyme having its
registered office at L-1445 Strassen, (Grand-Duchy of Luxembourg), 7, rue Thomas Edison, R.C.S. Luxembourg section
B number 146988, incorporated on June 26
st
, 2009 before Maître Blanche MOUTRIER, Notary residing at Esch-sur-
Alzette, deed published in the Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations number 1448 of July 27
th
, 2009
(hereafter “the Company”).
The Articles of Incorporation of the company have been amended on several occasions, most recently in the terms
of an instrument attested by Maître Blanche MOUTRIER, Notary of Esch-sur-Alzette, dated 7
nd
December 2011, pu-
blished in Mémorial No 103 of 13
th
January 2012.
The General Meeting was presided by Mrs. Evgeniya Demyanova Dumont having her professional address at 48 rue
Charles Martel, L-2134 Luxembourg,
The chairman appointed as secretary and scrutineer Mrs. Michèle Sensi-Bergami, having her professional address at
Esch-sur-Alzette.
The chairman declared and requested the notary to act:
I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that all the entire paid up
issued capital is duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon
the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, all the shareholders having agreed to meet after
examination of the agenda.
II. The attendance list, signed by the shareholders present, the proxy holders of the shareholders represented, the
members of the bureau and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed together with the proxies
and shall be filed at the same time with the registration authorities.
III. That the agenda of the present Extraordinary General Meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Transfer of the registered office of the Company from 7 rue Thomas Edison, L-1445 Strassen to 48 rue Charles
Martel, L-2134 Luxembourg;
2. Amendment of article 4, first paragraph of the articles of association;
3. Dissolution with immediate effect and voluntary liquidation of the Company;
4. Appointment of Mrs Simone Retter, professionally residing at 14, Avenue du X septembre, L-2550 Luxembourg, as
liquidator of the Company;
5. Determination of the powers of the Liquidator and the liquidation procedure of the Company;
6. Dismissal of managing directors of the company and discharge;
7. Appointment of keeper of the books and records of the company;
8. Miscellaneous.
After the foregoing was approved, the General Meeting unanimously took the following resolutions:
96378
L
U X E M B O U R G
<i>First resolutioni>
The Shareholders decides to transfer the registered office of the Company from 7, rue Thomas Edison Strassen, L-1445
to 48 rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.
<i>Second resolutioni>
The Shareholder decides to amend the first paragraph of article 4 of the Updated Articles (the “Articles”), which shall
henceforth have the following wording:
“The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.”
<i>Third resolutioni>
The General Meeting decides to dissolve the Company with immediate effect and to put it into voluntary liquidation.
<i>Fourth resolutioni>
The General Meeting decides to appoint as liquidator Mrs. Simone RETTER, Attorney in Law, professionally residing
at 14 avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg, born 13 June 1961 in Bettembourg (the “Liquidator”).
<i>Fifth resolutioni>
The General Meeting decides to grant the Liquidator with the broadest powers for the exercise of his mission, especially
those indicated in Article 144 to 148 of the Luxembourg law of August 10
th
1915 on commercial companies as amended.
The General Meeting further decides and acknowledges that the Company shall be bound towards third parties by
the sole signature of the Liquidator.
<i>Sixth resolutioni>
The General Meeting acknowledges of the dismissal of the board of directors and decides to grant full discharge to
the members of the board of directors for the exercise of their mandate up to the present day.
<i>Seventh resolutioni>
The General Meeting decides that the books and records of the company will be kept for five years by the liquidator
prenamed at L-2550 Luxembourg, 14 avenue du X Septembre.
There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on the request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancy between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the day named at the beginning of this
document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the present original deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille quatorze, le 23 mai.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, Notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché du Luxembourg).
S'est tenue
une Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme «Amigo Luxembourg S.A.» ayant son siège social à
L-1445 Strassen (Grand-Duché de Luxembourg), 7, rue Thomas Edison, R.C.S. Luxembourg section B numéro 146988,
constituée le 26 juin 2009 par devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, acte publié
au Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 1448 du 27 juillet 2009. (ci-après «la Société»).
Les statuts de la société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois aux termes d'un acte reçu par
Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 7 décembre 2011, publié au Mémorial
C numéro 103 du 13 janvier 2012.
L'Assemblée Générale était présidée par Madame Evgeniya Demyanova Dumont, demeurant professionnellement 48
rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.
Le président a désigné comme secrétaire et scrutateur Madame Michèle Sensi-Bergami, demeurant professionnelle-
ment à Esch-sur-Alzette.
Le président déclare et prie le notaire d'acter:
I. Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que l'intégralité du capital social
libéré et émis est dûment représentée à la présente Assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut
délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour ci-après reproduit, tous les actionnaires
ayant accepté de se réunir sans convocation préalable.
96379
L
U X E M B O U R G
II. Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous présents ou représentés, restera annexée au
présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregis-
trement.
III. Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Transfert du siège social de la société du 7 rue Thomas Edison, L-1445 Strassen vers le 48 rue Charles Martel,
L-2134 Luxembourg;
2. Modification de l'article 4 paragraphe 1 des statuts;
3. Dissolution avec effet immédiat et liquidation volontaire de la société;
4. Nomination de Madame Simone Retter, demeurant professionnellement au 14, Avenue du X septembre, L-2550
Luxembourg, en tant que liquidateur de la société;
5. Détermination des pouvoirs du liquidateur et de la procédure de liquidation de la Société.;
6. Démission du Conseil d'administration et décharge;
7. Tenue des livres et registres de la société;
8. Divers.
Après avoir délibéré, l'Assemblée Générale a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée Générale décide de transférer le siège social de la Société du 7, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen au
48 rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée Générale décide de modifier le premier paragraphe de l'article 4 des Statuts de la société (les «Statuts»)
afin de lui donner la teneur suivante:
“Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.»
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée Générale décide de dissoudre la Société avec effet immédiat et de la mettre en liquidation volontaire.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée Générale décide de nommer comme liquidateur de la société Madame Simone RETTER, Avocate, de-
meurant professionnellement à L-2550 Luxembourg, 14, Avenue du X Septembre, née le 13 juin 1961 à Bettembourg (le
“Liquidateur”).
<i>Cinquième résolutioni>
L'Assemblée Générale décide de conférer au Liquidateur les pouvoirs les plus larges pour effectuer sa mission, et, plus
spécialement ceux indiqués aux articles 144 jusque 148 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales ainsi que ses modifications.
L'Assemblée Générale, entre autre, décide et reconnaît que la Société sera engagée envers les tiers par la seule
signature du Liquidateur.
<i>Sixième résolutioni>
L'Assemblée Générale prend acte de la démission du Conseil d'administration et donne décharge pleine et entière aux
administrateurs pour l'exécution de leur fonction jusqu'à ce jour.
<i>Septième résolutioni>
L'Assemblée Générale décide que les livres et documents de la société seront conservés pendant cinq par le Liquidateur
prénommé à L-2550 Luxembourg, 14, Avenue du X Septembre.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande des comparants le présent acte est
en langue anglaise suivi d'une version française. A la demande des comparants et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
Dont procès-verbal, passé à Esch-sur-Alzette, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: WLODARCZAK, SENSI-BERGAMI, MOUTRIER.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 26/05/2014. Relation: EAC/2014/7345. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
96380
L
U X E M B O U R G
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.
Esch-sur-Alzette, le 28/05/2014.
Référence de publication: 2014075284/145.
(140088709) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2014.
Dune Stratégie S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5447 Schwebsange, 53, route du Vin.
R.C.S. Luxembourg B 152.766.
L'an deux mille quatorze, le vingt-trois mai.
Par devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch,
Ont comparu:
- Monsieur Arthur VOUAUX, chargé d'affaires, né le 6 mars 1981 à Nancy (F) et demeurant à F-54700 Maidières, 2
Avenue du Général Leclerc;
- Madame Noémie VOUAUX, employée-assistante de production, née le 17 décembre 1979 à Nancy (F) et demeurant
à F-54700 Maidières, 2 Avenue du Général Leclerc;
Ici représentés par Monsieur Eric VOUAUX, gérant de sociétés, né le 22 février 1954 à Nancy (F) et demeurant à
F-54700 Maidières, 2 Avenue du Général Leclerc, préqualifié, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, laquelle
restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
I.- Lesquels comparants, présents ou représentés comme dit ci-avant , ont requis le notaire soussigné d'acter qu'ils
sont les seuls associés de la société «Dune Stratégie S.à r.l.», une société à responsabilité limitée avec siège social à L-9237
Diekirch, 3, place Guillaume, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
152.766, constituée suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16
avril 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 1214 du 10 juin 2010, et dont les statuts ont
été modifiés en dernier lieu le 19 mai 2011 par acte de Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck, publié
au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations en 2011, n° 1690 (ci-après la "Société").
II.- Le capital social de la Société est de quinze mille euros (EUR 15.000) représenté par quinze mille (15.000) parts
sociales de un euro (EUR 1,00) chacune, toutes entièrement libérées, et appartient aux comparants comme suit:
- Monsieur Arthur VOUAUX, préqualifié,
Sept mille cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.500
- Madame Noémie VOUAUX, préqualifiée,
Sept mille cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.500
Total des parts: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000
III. Lesquels comparants, présents ou représentés comme dit ci-avant , ont reconnu être pleinement informés des
résolutions à prendre sur base de l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Transfert du siège social de la société de son adresse actuelle L-9237 Diekirch, 3, place Guillaume à l'adresse suivante:
L-5447 SCHWEBSANGE, 53, Route du Vin;
2. Modification subséquente du premier alinéa de l'article 4 des statuts de la Société.
3. Divers.
Après en avoir délibéré, le comparant, représenté comme dit ci-avant , a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés déclarent que le siège social de la Société à été transféré de son adresse actuelle L-9237 Diekirch, 3, place
Guillaume à l'adresse suivante: L-5447 SCHWEBSANGE, 53, Route du Vin.
<i>Deuxième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, les associés décident de modifier le premier
alinéa de l'article 4 des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
Art. 4. Le siège de la Société est établi dans la commune de Schengen.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépens, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la société en raison du
présent acte sont évalués approximativement à neuf cents euros (EUR 900.-).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Diekirch, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
96381
L
U X E M B O U R G
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, présents ou représentés comme dit ci-avant,, connus
du notaire instrumentaire par leur nom, prénom, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: E. VOUAUX, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 27 mai 2014. Relation: DIE/2014/6667. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.
<i>Le Receveuri> (signé) pd: RECKEN.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Diekirch, le 28 mai 2014.
Référence de publication: 2014075444/58.
(140089028) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2014.
E.T.T. European Trade and Transport S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 27.759.
DISSOLUTION
L'an deux mille quatorze, le seize mai.
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné;
A COMPARU:
Monsieur Daniele RIZZI, né le 22 octobre 1946 à Parme (Italie), demeurant à L-1466 Luxembourg, 10, rue Jean Engling,
ici représenté par Madame Sonia DELFINI, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle procuration, après avoir été signée “ne varietur” par
le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui
Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit ses
déclarations et constatations:
a) Que la société anonyme “E.T.T. EUROPEAN TRADE AND TRANSPORT S.A.”, (ci-après la "Société"), établie et
ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg, section B, sous le numéro 27759 a été constituée suivant acte reçu par Maître Francis KESSELER, alors
notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 8 avril 1988, publié au Mémorial C numéro 126 de 1998.
b) Que le capital social de la Société est fixé à cinquante-deux mille francs suisses (52.000,- CHF), représenté par mille
(1.000) actions d'une valeur nominale de cinquante-deux francs suisses (52,- CHF), entièrement libérées;
c) Que le comparant est devenu successivement propriétaire de toutes les actions de la Société (l'"Associé Unique");
d) Que l'activité de la Société ayant cessé, l'Associé Unique prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet
immédiat et sa mise en liquidation.
e) Que l'Associé Unique se désigne comme liquidateur de la Société et aura pleins pouvoirs d'établir, de signer, d'exé-
cuter et de délivrer tous actes et documents, de faire toute déclaration et de faire tout ce qui est nécessaire ou utile
pour mettre en exécution les dispositions du présent acte;
f) Qu'en sa capacité de liquidateur de la Société, l'Associé Unique requiert le notaire instrumentant d'acter qu'elle
déclare avoir réglé tout le passif de la Société ou l'avoir dûment provisionné et avoir transféré tous les actifs à son profit;
g) Que l'Associé Unique est investie de tous les éléments actifs de la Société et déclare reprendre de manière irré-
vocable tout le passif social et de tous les engagements de la Société même inconnus à ce jour;
h) Que l'Associé Unique prononce la clôture de la liquidation et constate que la Société a définitivement cessé d'exister
et qu'il n'a jamais été procédé à la création matérielle des actions de la société dissoute et qu'il n'existe pas de registre
d'actions.
i) Que décharge pleine et entière est donnée aux membres du conseil d'administration et au commissaire aux comptes
pour l'exécution de leur mandat jusqu'en date des présentes.
j) Que les livres et documents de la Société dissoute, seront conservés pendant cinq ans au moins à l'ancien siège social
à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à la somme de neuf cents euros et la
partie comparante, en tant qu'associé unique, s'y engage personnellement.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire du comparant, connue du notaire par nom, prénom,
état et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.
96382
L
U X E M B O U R G
Signé: S. DELFINI, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 22 mai 2014. LAC/2014/23632. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
Luxembourg, le 28 mai 2014.
Référence de publication: 2014075467/53.
(140089311) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2014.
Ecke Golden S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1424 Luxembourg, 6, rue André Duchscher.
R.C.S. Luxembourg B 162.576.
<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 9 mai 2014i>
<i>Ordre du jour:i>
1. Cession de parts sociales
<i>Résolutions prises:i>
L'associé unique:
1) Monsieur Bruno Miguel SARAIVA BORGES, chauffeur, né le 14 juin 1982 à Seia (Portugal), demeurant à L-3727
Rumelange, 12, rue Haute, (375 parts sociales)
2) Madame Ana Sofia FRANCA DA COSTA, serveuse, née le 2 février 1991 à Boa Ventura (Portugal), demeurant à
L-1130 Luxembourg, 58, rue d'Anvers (120 parts sociales)
3) Madame Celeste RODRIGUES DA SILVA GONCALVES, cafetière, née à Salvaterra de Magos (Portugal) le 12 mai
1969, demeurant à L-1130 Luxembourg, 57, rue d'Anvers (5 parts sociales)
de la société à responsabilité limitée ECKE GOLDEN, ayant son siège social à L-1424 Luxembourg, 6, rue André
Duchscher.
ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolution:i>
1) Monsieur Bruno Miguel SARAIVA BORGES, propriétaire de 375 parts de la société à responsabilité limitée ECKE
GOLDEN, établie et ayant son siège social à Luxembourg;
Monsieur Bruno Miguel SARAIVA BORGES cède et transporte, sous les garanties ordinaires et de droit à Monsieur
Krasimir Yuliyanov CHILIKOV né le 11 avril 1979 à Dabnitsa (Bulgarie) qui accepte 100 parts sociales de la société dont
s'agit.
2) Madame Ana Sofia FRANCA DA COSTA, propriétaire de 120 parts de la société à responsabilité limitée ECKE
GOLDEN, établie et ayant son siège social à Luxembourg;
Madame Ana Sofia FRANCA DA COSTA cède et transporte, sous les garanties ordinaires et de droit à Monsieur
Krasimir Yuliyanov CHILIKOV né le 11 avril 1979 à Dabnitsa (Bulgarie) qui accepte 100 parts sociales de la société dont
s'agit.
Madame Ana Sofia FRANCA DA COSTA cède et transporte, sous les garanties ordinaires et de droit à Madame
Celeste RODRIGUES DA SILVA GONCALVES, cafetière, née à Salvaterra de Magos (Portugal) le 12 mai 1969, qui accepte
20 parts sociales de la société dont s'agit.
Après la cession mentionnée ci-dessus (résolution unique), le capital social de la société ECKE GOLDEN S.à r.l.,
représenté par cent (500) parts sociales, est répartie comme suit:
Monsieur Bruno Miguel SARAIVA BORGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 parts sociales
Monsieur Krasimir Yuliyanov CHILIKOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 parts sociales
Madame Celeste RODRIGUES DA SILVA GONCALVES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 parts sociales
Total: cinq cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 parts sociales
96383
L
U X E M B O U R G
<i>Prixi>
Les présentes cessions sont consenties et acceptées moyennant le prix nominal des parts, montant que les cédants
reconnaissent avoir reçu et en donnant quittance.
Fait à Luxembourg, le 9 mai 2014, en 4 exemplaires.
Monsieur Bruno-Miguel SARAIVA BORGES /
Madame Ana Sofia FRANCA DA COSTA /
Madame Celeste RODRIGUES DA SILVA GONCALVES /
Monsieur Krasimir Yuliyanov CHILIKOV
Référence de publication: 2014075489/48.
(140087694) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2014.
Cascade, Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 173.362.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 28 mai 2014i>
- L'Assemblée ratifie la cooptation en tant qu'administrateur de Madame Nicoletta Leone, employée privée, avec
adresse professionnelle 40, Avenue Monterey à L-2163 Luxembourg. Son mandat se terminera lors de l'assemblée qui
statuera sur les comptes de l'exercice 2014.
- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Richard Knibb, directeur, avec adresse profes-
sionnelle 1, Bedford Square, WC1B3RB Londres et de Monsieur Peter Van Opstal, employé privé, avec adresse
professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-
VENTURES S.A., ayant son siège social 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de
l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2014.
Luxembourg, le 28 mai 2014.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2014075416/20.
(140089063) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2014.
Dynex Energy S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.
R.C.S. Luxembourg B 164.435.
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue extraordinairement en date du
22 mai 2014 que:
- les personnes suivantes ont démissionné de leur fonction d'Administrateurs de la Société, avec effet immédiat:
* Mme Geneviève BLAUEN-ARENDT, Présidente,
* Mme Annie SWETENHAM,
* M. Marc SCHMIT.
- les personnes suivantes ont été nommées à la fonction d'Administrateur de la Société, avec effet immédiat:
* M. Christian KRUPPA, avec adresse au 29, Palm Jumeira Frond C Villa, 72638 Dubai, Emirats Arabes Unis,
* M. Ludovico PEIRCE CHIANESE, avec adresse au 2, Via Sebenico, I-00198 Rome, Italie,
* M. Luciano PETTI, avec adresse au 59, Via Gravina di Puglia, I-00133 Rome, Italie,
* M. Luigi GIACUMBO, avec adresse au 51, Via Fra Giovanni Angelico, I-50121 Firenze, Italie.
Leur mandat expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2020;
- M. Christian KRUPPA a été nommé à la fonction de Président du Conseil d'Administration de la Société.
- La société MOTHERWELL SERVICES LIMITED a démissionné de sa fonction de commissaire aux comptes de la
Société et que la société International Audit Services S.à r.l., avec siège social au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Lu-
xembourg, a été nommée à la fonction de Réviseur d'entreprises agréé.
Son mandat expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2020.
Pour extrait conforme
SG AUDIT SARL
Référence de publication: 2014075445/26.
(140089300) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2014.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
96384
Amigo Luxembourg S.A.
Azul Finance S.à r.l.
Barbara Investissements S.A.
Bateman Luxembourg S.A.
Bau-Invest S.A.
Beekman Capital Luxembourg
Belilux Partners
BELLATRIX Asset Management S.A.
Berlin 1 S.à r.l.
Berlin Hof 3 S.à r.l.
Berlin Hof 4-5 S.à r.l.
Bienne SA
Bilfinger FRB S.à r.l.
Bodmin
Bodmin
BOP (Principal Place I) S.à r.l.
BPI Global Investment Fund Management Company S.A.
Breva S.A.
Bugy Capital S.à r.l.
Bugy Capital S.à r.l., SPF
BV Acquisitions MX S.à r.l.
Caelus Energy Indonesian Holdings Sàrl
Calcipar S.A.
Calimax 2 S.A.
Callaghan Square (Luxembourg) Holding S.à r.l.
Capital Safety Canada Holdings S.à r.l.
Cappartners S.A.
Capucins (Thionville) S.à r.l.
Capula ESS Lux 1 S.à r.l.
Capula ESS Lux 1 S.à r.l.
Cardoso Constructions S.à r.l.
Carmarguen Finance S.A.
Casaquira Holdings Sàrl
Cascade
Cavaliere Brands S.à r.l.
Centre Europe S.A.
CGFP Assurances
Chemring Luxembourg Finance
Chemring Luxembourg Holding
Cherryhill Holdings S.à r.l.
China Designer Outlet Mall S.A.
China Designer Outlet Mall S.A.
CLdN Bulk I S.A.
CoArt S.à r.l.
Comco MCS S.A.
Commercial Project Holdings S.à r.l.
Conadau S.A.-SPF
Covart Gallery S.à r.l.
Crèche La Petite Sirène S.à.r.l.
Credit Suisse Index Fund (Lux)
Credit Suisse Real Estate Fund International (Luxembourg) Holding S.A.
Crosstree Real Estate Finance S.à r.l.
Dialogiques
Dune Stratégie S.à r.l.
Dynex Energy S.A.
Ecke Golden S.à r.l.
Effeta Spf S.A.
Erdi S.A.
E.T.T. European Trade and Transport S.A.
Retkauf III S.à r.l.