This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2006
31 juillet 2014
SOMMAIRE
7H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96245
Adamed Finance Luxembourg S.à r.l. . . . .
96251
AddedValue S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96253
AE Lux HoldCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96243
Agence Générale Emili et Associés S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96247
Agence nationale pour le programme eu-
ropéen d'éducation et de formation tout
au long de la vie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96254
AI Garden Management & Cy S.C.A. . . . .
96255
A.J.I.L. C. & P. S.A., Consultants-Courtiers
en Assurances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96251
Aktiva Fonder Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96250
Alboni Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96285
Alexandre Immo International S.A. . . . . . .
96248
Allegro Investment Corporation S.A. . . . .
96254
Allseas Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96254
Alma Lasers S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96250
Alpha Union Invest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96250
Alpha Union Invest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96254
Altro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96288
ANEFORE Asbl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96254
Anglesea Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96255
Anglesea Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96287
APS Consult S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96252
ArcelorMittal Commercial Bars & Rods
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96251
ArcelorMittal Commercial RPS S.à r.l. . . .
96255
ArcelorMittal Commercial Sections S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96255
Arendt Services S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96249
Ateac Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96287
Axa Alternative Financing Management
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96288
Bamse S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96253
beeline Retail S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96246
B.R.E. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96288
CGFP Assurances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96252
Cordonnerie Minute S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
96249
d'Amico International Shipping S.A. . . . . .
96253
EPI Trinity S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96248
Fairfield 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96256
Fama International S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
96250
Konex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96249
Kulturell-sportlicher Verein "BOSNA" Lu-
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96242
Mamer Realty Inc S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
96251
Premier Properties Holding S.à r.l. . . . . . .
96246
Retkauf I S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96269
Valcourt S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96242
Valemi Corp S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96242
Valero Moselle Company S.à r.l. . . . . . . . . .
96248
VAT Lux II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96242
VCG JL Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96243
VCG JL Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96242
Velcan Energy Luxembourg S.A. . . . . . . . .
96252
Verites Vision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96243
Vigo Internacional S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
96243
Vila Verde S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96244
Vilcabamba S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96244
VO Consulting Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
96244
VPB Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96245
Westbury Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . .
96245
Westport Luxembourg S. à r.l. . . . . . . . . . .
96244
World Café S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96245
WPHD Welcome Private Hospitality De-
velopment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96246
WWIPPS S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96246
Xevin Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
96247
YPL Consulting S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96247
Zanbato Europe S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
96247
Zork S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96248
96241
L
U X E M B O U R G
Valcourt S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 158.655.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014075193/10.
(140088442) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2014.
Valemi Corp S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 164.021.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014075194/10.
(140087579) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2014.
VAT Lux II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: CHF 30.000,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 184.078.
<i>Extrait des Résolutions prises par l'associé unique en date du 26 Mai 2014i>
- Monsieur Jean-Robert Bartolini a démissionné en tant que gérant de catégorie C de la Société avec effet au 30 avril
2014;
- Mlle Rosalba Barretta, née le 3 janvier 1971 à Marsala (Italie), ayant son adresse professionnelle au 412F, route d'Esch,
L-1030 Luxembourg, a été nommée en tant que gérant de catégorie C de la Société, avec effet au 30 avril 2014 et jusqu'au
29 Janvier 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014075197/15.
(140087901) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2014.
VCG JL Sàrl, Société à responsabilité limitée soparfi.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 130.053.
Les comptes annuels au 31 octobre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014075199/10.
(140087783) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2014.
Kulturell-sportlicher Verein "BOSNA" Luxembourg, Association sans but lucratif.
Siège social: L-3843 Schifflange, 23, rue de l'industrie.
R.C.S. Luxembourg F 968.
Art. 6. Sitz des Vereins ist folgende Adresse:
23, rue de l'Industrie - L-3843 SCHIFFLANGE
Référence de publication: 2014075260/9.
(140087850) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2014.
96242
L
U X E M B O U R G
Verites Vision, Société Anonyme.
Siège social: L-8832 Rombach, 5, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 184.569.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Référence de publication: 2014075202/10.
(140087446) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2014.
Vigo Internacional S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 176.445.
Par la présente, je soussigné, Monsieur Fabio MASTROSIMONE, ai l'honneur de vous informer que je me démets de
mes fonctions d'Administrateur de catégorie B au sein de votre société avec effet immédiat.
Le 14/5/2014.
Fabio MASTROSIMONE.
Référence de publication: 2014075204/10.
(140087991) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2014.
VCG JL Sàrl, Société à responsabilité limitée soparfi.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 130.053.
<i>Decision of the sole partner April 29. 2014i>
The sole Partner decides to renew PriceWaterhouseCoopers Société Coopérative, 400 route d'Esch, L - 1014 Lu-
xembourg as Independent Auditor of the Company.
The mandate of the Independent Auditor will expire upon the Annual General Meeting which will approve the accounts
for the year ending October 31, 2014.
Version Française
<i>Décision de l'associé unique du 29 avril 2014i>
L'Associé unique décide de nommer PriceWaterhouseCoopers Société Coopérative, 400 route d'Esch, L - 1014 Lu-
xembourg en tant que Réviseur d'Entreprises Agréé de la Société.
Le mandat du Réviseur d'Entreprises Agréé viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui approuvera
les comptes annuels clôturés au 31 octobre 2014.
Copie certifiée conforme
VCG JL Sarl
Signatures
<i>Gérant / Géranti>
Référence de publication: 2014075198/23.
(140087782) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2014.
AE Lux HoldCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 181.614.
Les statuts coordonnés au 5 mai 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Marc Loesch
<i>Notairei>
Référence de publication: 2014075298/11.
(140089417) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2014.
96243
L
U X E M B O U R G
Vila Verde S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6170 Godbrange, 27, rue du Village.
R.C.S. Luxembourg B 92.646.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour le géranti>
Référence de publication: 2014075205/10.
(140087809) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2014.
Vilcabamba S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8350 Garnich, 67, An der Merzel.
R.C.S. Luxembourg B 150.127.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 avril 2013.
Référence de publication: 2014075207/10.
(140088520) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2014.
VO Consulting Lux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8399 Windhof, 6, rue d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 61.459.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associée unique en date du 22 avril 2014 à Windhofi>
L'associée unique de la société VO CONSULTING LUX S.A. a pris la résolution suivante:
1. Le mandat d'administrateur de Monsieur Cédric Rensonnet étant arrivé à terme, celui-ci est renouvelé pour une
durée de six ans et ce, rétroactivement à compter du 7 décembre 2013.
L'adresse de l'administrateur Cédric Rensonnet est désormais la suivante: Rue de la Halte, 33 à B-6780 Messancy.
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2014075211/14.
(140087655) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2014.
Westport Luxembourg S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 172.805.
Il résulte des résolutions prises, approuvées et ratifiées par l'actionnaire unique de la Société en date du 20 mai 2014
qu'il a été décidé à l'unanimité:
- d'accepter la démission de Mademoiselle Xenia Kotoula en tant que gérant de catégorie B de la Société avec effet
au 28 février 2014; et
- de nommer en remplacement du gérant démissionnaire, en tant que nouvel gérant de catégorie B de la Société avec
effet immédiat au 20 mai 2014, Monsieur Jacob Mudde, né le 14 octobre 1969 à Rotterdam., Pays-Bas, ayant son adresse
professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg et pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mai 2014.
<i>Pour la société
i>TMF Luxembourg S.A.
Signatures
<i>Signataire autoriséi>
Référence de publication: 2014075213/20.
(140087812) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2014.
96244
L
U X E M B O U R G
VPB Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 26, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 42.828.
Par la présente, nous vous informons que Monsieur Joachim Kuske, domicilié professionnellement à 26, avenue de la
Liberté, administrateur de la société VPB Finance S.A., numéro RCS Luxembourg B 42 828, 26, avenue de la Liberté,
L-1930 Luxembourg, a démissionné de son poste d'administrateur de la société VPB Finance S.A. avec effet au 20 mai
2014.
Luxembourg, le 20 mai 2014.
VPB Finance S.A.
Signatures
Référence de publication: 2014075212/14.
(140087527) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2014.
Westbury Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 155.234.
<i>Rectificatif des comptes annuels révisés au 31 décembre 2012 et déposés au registre de commerce et des sociétés le 16 juilleti>
<i>2013 sous la référence L130120022.i>
Les comptes annuels révisés au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Luxembourg Corporation Company S.A.
Signature
Référence de publication: 2014075217/15.
(140088306) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2014.
World Café S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 12-14, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 144.260.
Le bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mai 2014.
Référence de publication: 2014075218/10.
(140087921) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2014.
7H, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 115.479.
<i>Extrait des décisions prises par voie de résolution circulaire en date du 21 mai 2014i>
En date du 21 mai 2014, le Conseil d'Administration a décidé:
- d'accepter les démissions, avec effet au 19 mai 2014, de Monsieur Gabriele Bartolucci, Monsieur Moataz El Sherif et
de Monsieur Siegieri Diaz della Vittoria Pallavicini en qualité d'Administrateurs.
Luxembourg, le 27 mai 2014.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour 7h
i>CACEIS Bank Luxembourg
Référence de publication: 2014075231/15.
(140088269) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2014.
96245
L
U X E M B O U R G
WPHD Welcome Private Hospitality Development S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 7, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 174.733.
<i>Extrait des résolutions prises par l'actionnaire unique en date du 12 mai 2014i>
1. L'associé unique décide d'accepter la démission de M. Fabrice GEIMER en tant qu'administrateur de la Société, avec
effet immédiat.
2. L'Associé unique décide d'accepter la démission de M. Jean FELL en tant qu'administrateur de la Société, avec effet
immédiat.
Luxembourg, 23 mai 2014.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour WPHD WELCOME PRIVATE HOSPITALITY DEVELOPMENT S.A.
i>United International Management S.A.
Référence de publication: 2014075219/16.
(140087951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2014.
WWIPPS S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5612 Mondorf-les-Bains, 13, avenue François Clement.
R.C.S. Luxembourg B 95.536.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014075220/10.
(140088346) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2014.
beeline Retail S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 35, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 127.527.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014075270/10.
(140089386) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2014.
Premier Properties Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.
R.C.S. Luxembourg B 121.888.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
Par jugement rendu en date du 22 mai 2014, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,
siégeant en matière commerciale, après avoir entendu Madame la vice-présidente Anick WOLFF, en remplacement du
juge-commissaire dûment empêché, le liquidateur et le Ministère Public en leurs conclusions, a déclaré closes pour in-
suffisance d'actif les opérations de liquidation de:
- La société à responsabilité limitée PREMIER PROPERTIES HOLDING SARL (RCS B121888), avec siège social à L-2168
LUXEMBOURG 127, rue de Mühlenbach
Le même jugement a dit que les frais sont à prélever sur l'actif réalisé, le solde étant à charge du Trésor.
Pour extrait conforme
Maître Maïka SKOROCHOD
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2014075263/18.
(140088430) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2014.
96246
L
U X E M B O U R G
Xevin Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 140.065.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014075221/10.
(140087474) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2014.
YPL Consulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-1409 Luxembourg, 10, rue Edmond Dune.
R.C.S. Luxembourg B 116.714.
<i>Extrait de résolution de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés du 29.10.2013i>
L'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés de la société YPL CONSULTING S.à r.l. réuni le 29.10.2013 a
décidé à l'unanimité ce qui suit:
1. Révoquer Monsieur Jacov LEVAV, de son mandat de gérant.
2. Nommer Madame Osnat LEVAV, née le 30 août 1972 à Haifa, ISRAEL, demeurant à L-1409 Luxembourg, 10 Rue
Edmond Dune, au poste de gérante.
Fait à Luxembourg, le 29.10.2013.
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2014075223/16.
(140087867) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2014.
Zanbato Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 168.849.
Le Bilan et l’affectation du résultat au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mai 2014.
Zanbato Europe S.à.r.l.
Nathalie S.E. Chevalier
<i>Manager Ai>
Référence de publication: 2014075224/14.
(140088120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2014.
Agence Générale Emili et Associés S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4040 Esch-sur-Alzette, 14, rue Xavier Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 150.750.
Les Comptes annuels révisés au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 28 mai 2014.
Agence Générale Emili et Associés S.à r.l.
Laurent HEILES
<i>Géranti>
Référence de publication: 2014075279/14.
(140088661) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2014.
96247
L
U X E M B O U R G
Zork S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 50.110.
J'ai l'honneur de vous remettre, par la présente, ma démission en tant que Commissaire aux Comptes de votre société
avec effet ce jour.
Luxembourg, le 22 avril 2014.
Eric HERREMANS.
Référence de publication: 2014075229/10.
(140088217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2014.
Valero Moselle Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 772.750,00.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 161.858.
Il est a noter que l'associé de la Société, Ultramar Ltd., une société dûment constituée sous les lois du Canada, dont
le siège social est sis au 2200 McGill College Avenue, Montreal, Quebec H3A 3L3, Canada, a changé de dénomination
sociale et se nomme désormais Valero Energy, Inc.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mai 2014.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2014075250/15.
(140087290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
EPI Trinity S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 96.938.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 9 avril 2014i>
L'associé unique de la Société:
- approuve le rapport de l'auditeur à la liquidation;
- prononce la clôture de la liquidation et constaté que la Société a définitivement cessé d'exister en date du 9 avril
2014;
- décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans à l'adresse
suivante: Alter Domus Liquidation Services 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 avril 2014.
EPI Trinity S.à r.l., en liquidation volontaire
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2014075257/20.
(140088298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2014.
Alexandre Immo International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3895 Foetz, rue de l'Industrie, Coin des Artisans.
R.C.S. Luxembourg B 120.066.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014075302/9.
(140089153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2014.
96248
L
U X E M B O U R G
Cordonnerie Minute S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1726 Luxembourg, 4, rue Pierre Hentges.
R.C.S. Luxembourg B 48.186.
LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugement rendu en date du 30 juin 2005, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
commerciale, a prononcé la dissolution et ordonné la liquidation de:
- La société à responsabilité limitée CORDONNERIE MINUTE SARL (RCS 48.186), avec siège social à L-1726 Lu-
xembourg-4, Rue Pierre Hentges
Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Jean Pierre MEYERS Juge au tribunal d'arrondissement de et
à Luxembourg, et désigné liquidateur Maître Nathalie NIMESGERN, avocat, demeurant à Luxembourg.
Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances au Greffe du Tribunal de Commerce avant le 20
juillet 2005.
Pour extrait conforme
Maître Nathalie NIMESGERN
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2014075255/19.
(140088427) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2014.
Konex, Société Anonyme.
Siège social: L-1338 Luxembourg, 46, rue du Cimetière.
R.C.S. Luxembourg B 127.436.
<i>Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires le 8 mai 2014i>
<i>Quatrième résolutioni>
Les mandats des administrateurs Romain Braas, Claude Meyer, Daniel Frank, Wim Kinnet et Laurent Heiles, venant à
échéance, l'Assemblée décide de procéder au renouvellement de leurs mandats pour une période d'un an. Leurs mandats
expirent donc à l'Assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2014.
<i>Cinquième résolutioni>
L'Assemblée décide de renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes, Madame Carmen Gerling-Monz, venant
à échéance, pour la période expirant à l'Assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2014.
Daniel FRANK
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2014075261/17.
(140087684) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2014.
Arendt Services S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 145.917.
<i>Extrait des résolutions circulaires prises par le conseil d'administration de la Société en date du 26 mai 2014i>
En date du 26 mai 2014, le conseil d'administration de la Société a pris la résolution suivante:
- de nommer Monsieur Olivier HAMOU, né le 19 décembre 1973 à Levallois-Perret, France, résidant professionnel-
lement à l'adresse suivante: 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, en tant que délégué à la gestion journalière de la
Société avec effet au 15 mai 2014 et ce pour une durée indéterminée.
L'adresse de l'administrateur, Monsieur Michel RAFFOUL, est désormais la suivante:
- 1, rue de la Monnaie, L-2150 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mai 2014.
Arendt Services S.A.
Signature
Référence de publication: 2014075289/18.
(140088937) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2014.
96249
L
U X E M B O U R G
Alma Lasers S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 171.951.
Les comptes annuels au 31-12-2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014075303/9.
(140088901) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2014.
Alpha Union Invest, Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 78.689.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014075304/9.
(140089112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2014.
Fama International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1463 Luxembourg, 21, rue Fort Elisabeth.
R.C.S. Luxembourg B 46.755.
LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugement rendu en date du 30 juin 2005, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
commerciale, a prononcé la dissolution et ordonné la liquidation de:
- La société à responsabilité limitée FAMA INTERNATIONAL Sàrl (RCS 46755), avec siège social à L-1463 Luxembourg
- 21, Rue Fort Elisabeth.
Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Jean Pierre MEYERS Juge au tribunal d'arrondissement de et
à Luxembourg, et désigné liquidateur Maître Nathalie NIMESGERN, avocat, demeurant à Luxembourg.
Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances au Greffe du Tribunal de Commerce avant le 20
juillet 2005.
Pour extrait conforme
Maître Nathalie NIMESGERN
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2014075259/19.
(140088426) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2014.
Aktiva Fonder Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 155.251.
<i>Résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire de la SICAV en date du 28 mai 2014i>
L'Assemblée Générale Ordinaire a pris les décisions suivantes:
1. de renouveler le mandat de
- Monsieur Christer HULTBLAD
- Madame Florence PILOTAZ
- Monsieur Nico THILL
comme administrateurs de la SICAV jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2015
2. de renouveler le mandat de Mazars en tant que Réviseur d'entreprises agréé de la SICAV jusqu'à l'Assemblée
Générale Ordinaire qui se tiendra en 2015
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014075301/17.
(140088997) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2014.
96250
L
U X E M B O U R G
Mamer Realty Inc S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8269 Mamer, 1, rue Wieseck.
R.C.S. Luxembourg B 55.287.
LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugement rendu en date du 30 juin 2005, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
commerciale, a prononcé la dissolution et ordonné la liquidation de:
- La société à responsabilité limitée MAMER REALTY INC Sàrl (RCS 55287), avec siège social à L-.8269 MAMER - 1,
Rue Wieseck.
Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Jean Pierre MEYERS Juge au tribunal d'arrondissement de et
à Luxembourg, et désigné liquidateur Maître Nathalie NIMESGERN, avocat, demeurante Luxembourg.
Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances au Greffe du Tribunal de Commerce avant le 20
juillet 2005.
Pour extrait conforme
Maître Nathalie NIMESGERN
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2014075262/19.
(140088424) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2014.
A.J.I.L. C. & P. S.A., Consultants-Courtiers en Assurances, Société Anonyme.
Siège social: L-9964 Huldange, 21, Stawelerstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 68.314.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014075272/10.
(140089219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2014.
Adamed Finance Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 181.021.
Les comptes annuels de la société Adamed Finance Luxembourg S.à r.l. au 31/12/2013 ont été déposés au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014075273/10.
(140088933) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2014.
ArcelorMittal Commercial Bars & Rods, Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 49.668.
L'Assemblée générale tenue extraordinairement le 27 mai 2014, a pris acte de la démission de Monsieur Sandeep
JALAN, administrateur démissionnaire.
L'Assemblée générale a décidé de nommer comme nouvel administrateur Monsieur Jean-Paul ORDIONI, avec adresse
professionnelle au 66 rue de Luxembourg, L-4221 Esch-sur-Alzette.
Monsieur ORDIONI est nommé pour une période de quatre (4) ans. Son mandat viendra à expiration lors de l'as-
semblée générale annuelle à tenir en l'an 2018.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mai 2014.
Référence de publication: 2014075286/15.
(140088822) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2014.
96251
L
U X E M B O U R G
Velcan Energy Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 99.357.700,00.
Siège social: L-1651 Luxembourg, 11, avenue Guillaume.
R.C.S. Luxembourg B 145.006.
<i>Extrait du procès-verbal des décisions de l'associé unique du 14 mai 2014i>
En date du 14 mai 2014, l'actionnaire unique de la société VELCAN ENERGY LUXEMBOURG S.A. a pris les décisions
suivantes (septième décision):
- de ne pas renouveler le mandat de Réviseur d'Entreprises Agréé de GRANT THORNTON LUX AUDIT;
- de nommer comme Réviseur d'Entreprises Agréé de la Société, la société BDO Audit ayant son siège social au 2,
avenue Charles de Gaulle L-1653 Luxembourg inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 147
570, pour une période de deux ans qui prendra fin à l'issue de l' Assemblée Générale ordinaire des actionnaires à tenir
dans l'année 2016 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour VELCAN ENERGY LUXEMBOURG S.A.
i>Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2014075269/20.
(140088284) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2014.
CGFP Assurances, Société Anonyme.
Siège social: L-1468 Luxembourg, 16, rue Erasme.
R.C.S. Luxembourg B 166.988.
<i>Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires le 8 mai 2014i>
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée prend acte de la démission de Monsieur Joseph Daleiden, demeurant à L-7303 Steinsel, 9, rue des Etangs,
comme administrateur de la société, intervenue le 23 avril 2014.
L'Assemblée procède à la nomination de Monsieur Georges Muller, né le 21 février 1961 à Luxembourg, demeurant
à L-1219 Luxembourg, 5, rue Beaumont, comme nouvel administrateur de la société, pour une période d'un an à compter
de ce jour. Son mandat expire donc à l'Assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2014.
Les mandats des administrateurs Paul-Henri Meyers, Paul Zimmer, André Bredimus, Romain Braas et Daniel Frank,
venant à échéance, l'Assemblée décide de procéder au renouvellement de leurs mandats pour une période d'un an. Leurs
mandats expirent donc à l'Assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2014.
<i>Cinquième résolutioni>
L'Assemblée décide de renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes, Madame Carmen Gerling-Monz, venant
à échéance, pour la période expirant à l'Assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2014.
CGFP Assurances
Daniel FRANK
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2014075254/23.
(140087688) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2014.
APS Consult S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7447 Lintgen, 11, Bei de Fëschweieren.
R.C.S. Luxembourg B 114.818.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Monsieur Alfred PETERS
<i>Le gérant techniquei>
Référence de publication: 2014075315/11.
(140088841) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2014.
96252
L
U X E M B O U R G
d'Amico International Shipping S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 124.790.
<i>Extrait de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 2 avril 2014i>
L'Assemblée nomme au poste de réviseur d'entreprises la société PricewaterhouseCoopers RC LUXEMBOURG
B065477, L1471 LUXEMBOURG, 400, route d'Esch, en remplacement de la MOORE STEPHENS AUDIT SARL. Le mandat
expirera en l'an 2017.
Les mandats des administrateurs suivants sont renouvelés jusqu'à l'an 2017
Mr. Paolo D'AMICO, Via delle botteghe oscure, 32, I-00198 rome – Italie
Mr. Cesare D'AMICO, Via Panama, 88, I-00198 ROME – Italie
Mr. Marco FIORI, Boulevard de Suisse, 20, MC-98000 MONTE CARLO – MONACO
Mr. Giovanni BARBERIS, Via Disisione Torino, 60 I-00198 ROME – Italie
Mr. Massimo CASTROGIOVANNI, Via Panaro, 3, I-00199 ROMA -Italie
Mr. John J. DANILOVICH, Lowndes House, Lowndes Place, SW1X 8D8 Londres - Royaume-Uni
Mr. Heinz P. BARANDUN, Hinterbergstrasse 56, CH-8044 ZURICH - Suisse
Mr. Stas A. JOZWIAK, Oxford Lodge Northfield End Henley - RG9 2JJ Oxfordshire, Royaume-Uni
Mr. Giovanni Battista NUNZIANTE, 4, Via del Velabro, Rome- Italie
Référence de publication: 2014075271/21.
(140089217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2014.
AddedValue S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 1, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 102.378.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 5 mars 2014i>
L'Assemblée Générale décide de renouveler les mandats des administrateurs pour une durée de six ans, jusqu'à l'As-
semblée générale ordinaire de 2020.
L'Assemblée Générale décide de reconduire le mandat du commissaire aux comptes «KF FIDUCIAIRE SA» pour une
durée de six ans, jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire de 2020 qui statuera sur les résultats de l'exercice 2019.
Le siège social du commissaire aux comptes «KF FIDUCIAIRE SA» est transféré 7, rue de Bitbourg, à L-1273 Luxem-
bourg au 20, rue des Peupliers, à L-2328 Luxembourg
L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat de l'administrateur-délégué pour une durée de six ans, jusqu'à
l'Assemblée générale ordinaire de 2020.
Référence de publication: 2014075274/16.
(140088836) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2014.
Bamse S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 164.593.
Changement d'adresse de Monsieur Leif AHLQVIST, associé:
Quellenstrasse 73A/Top 24
1100 Vienne
AUTRICHE
Changement d'adresse de Madame Christina BRATT, associée:
Sikvägen 22
13541 Tyresö
SUEDE
<i>Pour la société
Un géranti>
Référence de publication: 2014075358/17.
(140088082) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2014.
96253
L
U X E M B O U R G
ANEFORE Asbl, Association sans but lucratif,
(anc. Agence nationale pour le programme européen d'éducation et de formation tout au long de la vie).
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg F 792.
<i>Assemblée générale extraordinaire du 23 mai 2014i>
La dénomination «Agence nationale pour le programme européen d'éducation et de formation tout au long de la vie
(Anefore), Asbl, Association sans but lucratif» est changée en «ANEFORE Asbl, Association sans but lucratif».
Les articles 1 et 3 sont modifiés comme suit:
Art. 1
er
. L'association est dénommée ANEFORE et a son siège à Luxembourg.
Art. 3. L'association a pour objet la mise en œuvre de programmes européens d'éducation et de formation tout au
long de la vie, notamment le Programme européen d'éducation et de formation tout au long de la vie (2007-2013), les
volets Education et Formation du Programme Erasmus+ (2014-2020) et les programmes européens concernant l'Educa-
tion et la Formation qui succéderont au programme Erasmus+ après 2020.
Elle a en outre pour mission d'exécuter et de clôturer les opérations relatives aux conventions conclues avec la
Commission européenne avant le 1
er
janvier 2007 et se rapportant aux anciens programmes européens Leonardo da
Vinci et Socrates.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014075278/21.
(140088543) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2014.
Allegro Investment Corporation S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 82.192.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014075282/10.
(140089274) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2014.
Allseas Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 148.778.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 28 mai 2014.
Référence de publication: 2014075283/10.
(140089399) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2014.
Alpha Union Invest, Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 78.689.
<i>Extrait des résolutions de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 28 avril 2014i>
Est nommé réviseur d'entreprises agréé, son mandat expirant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes au 31 décembre 2014:
- FIDEWA - CLAR S.A., 2 - 4, rue du Château d'Eau, L - 3364 Leudelange,
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 28 avril 2014.
Référence de publication: 2014075305/13.
(140089115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2014.
96254
L
U X E M B O U R G
ArcelorMittal Commercial RPS S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 17.250.000,00.
Siège social: L-4221 Esch-sur-Alzette, 66, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 27.031.
L'Assemblée générale tenue extraordinairement le 27 mai 2014, a pris acte de la démission de Monsieur Sandeep
JALAN, administrateur démissionnaire.
L'Assemblée générale a décidé de nommer comme nouvel administrateur Monsieur Jean-Paul ORDIONI, avec adresse
professionnelle au 66 rue de Luxembourg, L-4221 Esch-sur-Alzette.
Monsieur ORDIONI est nommé pour une période de six (6) ans. Son mandat viendra à expiration lors de l'assemblée
générale annuelle à tenir en l'an 2020.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mai 2014.
Référence de publication: 2014075287/16.
(140088845) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2014.
ArcelorMittal Commercial Sections S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4221 Esch-sur-Alzette, 66, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 36.177.
L'Assemblée générale tenue extraordinairement le 27 mai 2014, a pris acte de la démission de Monsieur Sandeep
JALAN, administrateur démissionnaire.
L'Assemblée générale a décidé de nommer comme nouvel administrateur Monsieur Jean-Paul ORDIONI, avec adresse
professionnelle au 66 rue de Luxembourg, L-4221 Esch-sur-Alzette.
Monsieur ORDIONI est nommé pour une période de un (1) an. Son mandat viendra à expiration lors de l'assemblée
générale annuelle à tenir en l'an 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mai 2014.
Référence de publication: 2014075288/15.
(140088857) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2014.
AI Garden Management & Cy S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.
R.C.S. Luxembourg B 178.029.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 27 mai 2014.
Référence de publication: 2014075299/10.
(140088620) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2014.
Anglesea Capital, Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 122.777.
Par la présente, nous vous informons que nous avons dénoncé, avec effet immédiat, le contrat de domiciliation conclu
avec la société sous rubrique, qui avait son siège au 15 rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg.
Luxembourg, le 27 mai 2014.
<i>Pour Vistra (Luxembourg) S.à r.l.
Société domiciliataire
i>Wim Rits / Alan Bofield
<i>Gérant / Géranti>
Référence de publication: 2014075309/13.
(140088979) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2014.
96255
L
U X E M B O U R G
Fairfield 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 78.752,60.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 185.390.
In the year two thousand and fourteen, on the twenty-eighth day of April.
Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
1) Fairfield L.P., a limited partnership registered under the laws of Guernsey with registration number 2042, having its
registered office at PO Box 255, Trafalgar Court, Les Banques, St. Peter Port, Guernsey GY1 3QL (“Fairfield L.P.”), being
the holder of [two hundred seventy-six thousand eight hundred eighty (276,880) A1 Shares, (ii) two hundred seventy-six
thousand eight hundred eighty (276,880) Class A2 Shares, (iii) two hundred seventy-six thousand eight hundred eighty
(276,880) Class A3 Shares and (iv) two hundred seventy-six thousand eight hundred eighty (276,880) Class A4 Shares,
here represented by Ikrame Dabaj, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given by way of a
private instrument,
2) Mr. Barend Franciscus Johannes van den Hoek, born on 27 December 1957 in Zierikzee (the Netherlands), residing
at 4 Boyd Close, Mooroolbark, Victoria, 3138, Australia, being the holder of (i) one hundred seventy-one (171) Class A1
shares, (ii) one hundred seventy-one (171) Class A2 shares, (iii) one hundred seventy-one (171) Class A3 shares, (iv) one
hundred seventy-one (171) Class A4 shares, (v) eight hundred thirty-nine (839) Class B1 shares, (vi) eight hundred thirty-
nine (839) Class B2 shares, (vii) eight hundred thirty-nine (839) Class B3 shares and (viii) eight hundred thirty-nine (839)
Class B4 shares,
here represented by Ikrame Dabaj, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given by way of a
private instrument,
3) Mr. Andrew Michael Copson, born 21 October 1963 in Aldershot (United Kingdom), residing at 6 Westport Manor,
Gastons Road, Malmesbury, SN16 0FE, United Kingdom, being the holder of (i) one hundred thirty-two (132) Class A1
shares, (ii) one hundred thirty-two (132) Class A2 shares, (iii) one hundred thirty-two (132) Class A3 shares, (iv) one
hundred thirty-two (132) Class A4 shares, (v) one thousand three hundred eighteen (1,318) Class B1 shares, (vi) one
thousand three hundred eighteen (1,318) Class B2 shares, (vii) one thousand three hundred eighteen (1,318) Class B3
shares and (viii) one thousand three hundred eighteen (1,318) Class B4 shares,
here represented by Ikrame Dabaj, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given by way of a
private instrument,
4) S&L Casey Superannuation Fund, a Self-Managed Superannuation Fund registered with the Australian Tax Office
(ATO) under number 13 689 063 228, having its registered office at 2/322 Cotham Road, Kew, Victoria 3101, Australia,
being the holder of (i) one hundred sixty (160) Class A1 shares, (ii) one hundred sixty (160) Class A2 shares, (iii) one
hundred sixty (160) Class A3 shares, (iv) one hundred sixty (160) Class A4 shares, (v) seven hundred nineteen (719)
Class B1 shares, (vi) seven hundred nineteen (719) Class B2 shares, (vii) seven hundred nineteen (719) Class B3 shares
and (viii) seven hundred nineteen (719) Class B4 shares,
here represented by Ikrame Dabaj, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given by way of a
private instrument,
5) Fairfield 2014 Employee Benefit Trust, a trust incorporated under the laws of Jersey and constituted by a trust
instrument dated 23 April 2014 between Appleby Trust (Jersey) Limited incorporated and registered in Jersey with
company number 21755 whose registered office is at 13-14 Esplanade, St Helier, Jersey, JE1 1BD (as trustee) and Fairfield
Bidco Limited (as settlor), being the holder of (i) twenty-two thousand one hundred ninety-one (22,191) Class B1 shares,
(ii) twenty-two thousand one hundred ninety-one (22,191) Class B2 shares, (iii) twenty-two thousand one hundred ninety-
one (22,191) Class B3 shares, (iv) twenty-two thousand one hundred ninety-one (22,191) Class B4 shares and (v) one
hundred one thousand (101,000) Class C shares,
here represented by Ikrame Dabaj, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given by way of a
private instrument,
The said proxies, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary, shall remain annexed
to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing parties are the shareholders of Fairfield 1 S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and
existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 46A avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
under number B 185390, incorporated pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary, residing in Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, on 5 March 2014, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
(hereafter the "Company"). The articles of incorporation of the Company were last amended pursuant to a deed of the
undersigned notary dated 25 April 2014, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
96256
L
U X E M B O U R G
The appearing parties, representing the entire share capital, requested the undersigned notary to enact that the agenda
of the meeting is as follows:
<i>Agendai>
1. Acceptance of Mr. David George Beeby, Mr. John Fell, Mr. Wayne Middleton, Mr. Joseph James Piccione, Mr. Ian
Robinson, Mr. Andrew Edward Bayliff, Mr. George Wilson Allan, Mr. Dominic Mark Heaton, Dmwake Superannuation
Fund, I&F Stacey Pty Limited, Schooner Superannuation Fund, Coonan Family Superannuation Fund, Paul4Viv Pty Limited,
Mr. Gary Fairless Power, Mr. Jaime Pacreu Vizcaya, Mr. Malcolm Fallen and Threewise Superannuation Fund as new
shareholders of the Company;
2. Increase of the share capital by an amount of thirteen thousand two hundred twenty euro and sixty cents (EUR
13,220.60) up to seventy-eight thousand seven hundred fifty-two euro and sixty cents (EUR 78,752.60) through the
issuance of (i) ten thousand one hundred fifty-eight (10,158) Class A1 Shares, (ii) ten thousand one hundred fifty-eight
(10,158) Class A2 Shares, (iii) ten thousand one hundred fifty-eight (10,158) Class A3 Shares and (iv) ten thousand one
hundred fifty-eight (10,158) Class A4 Shares, (v) twenty-nine thousand six hundred ninety-five (29,695) Class B1 shares,
(vi) twenty-nine thousand six hundred ninety-five (29,695) Class B2 shares, (vii) twenty-nine thousand six hundred ninety-
five (29,695) Class B3 shares and (viii) twenty-nine thousand six hundred ninety-five (29,695) Class B4 shares and one
hundred five thousand, (ix) (105,000) Class C Shares, all having a nominal value of five cents (EUR 0.05) each;
3. Decision to amend article 5.1. of the articles of association of the Company;
4. Miscellaneous.
Such appearing parties, representing the entire share capital, took the following resolutions:
<i>First resolution:i>
The general meeting of shareholders accepts (i) Mr. David George Beeby, born on 11 August 1952 in Nottingham
(United Kingdom), residing at The Ghyll, Cockermouth, Cumbria, CA13 0NY, United Kingdom, (ii) Mr. John Fell, born
on 4 May 1956 in Carlisle, Cumbria (United Kingdom), residing at Glynsdale Cottage, Aikhead, Cumbria, CA7 0EJ, United
Kingdom, (iii) Mr. Wayne Middleton, born on 15 February 1969 in Carlisle, Cumbria (United Kingdom), residing at
Midtown Barn, High Brigham, Cockermouth, Cumbria, CA13 0TB, United Kingdom, (iv) Mr. Joseph James Piccione, born
on 28 October 1961 in Columbus, Ohio (United States of America), residing at 2901 Perrington Way, Maritetta, GA,
30066, United States of America, (v) Mr. Ian Robinson, born on 7 February 1959 in Portsmouth (United Kingdom), residing
at Holme View, High Bridge, Dalston, Carlisle, CA5 7DR, United Kingdom, (vi) Mr. Andrew Edward Bayliff, born on 16
February 1961 in Ulverston, Cumbria (United Kingdom), residing at Vale House, Curthwaite, Wigton, Cumbria, CA7
8BG, United Kingdom, (vii) Mr. George Wilson Allan, born on 3 January 1963 in Glasgow (Scotland), residing at Linsum,
Beaumont, Carlisle, CA5 6EF, United Kingdom, (viii) Mr. Dominic Mark Heaton, born on 14 September 1972 in Oxford
(United Kingdom), residing at 2 Holmewood Paddock, Cockermouth, Cumbria, CA13 0AN, United Kingdom, (ix)
Dmwake Superannuation Fund, a Self-Managed Superannuation Fund registered with the Australian Tax Office (ATO)
under number 18 317 077 316 having its registered office at Multiport Level 1, 1 Chifley Square, Sydney, New South
Wales 2000, Australia, (x) I&F Stacey Pty Limited, a Self-Managed Superannuation Fund registered with the Australian
Tax Office (ATO) under number 28 605 532 768 having its registered office at 11 York Street, St Kilda West, Victoria
3182, Australia, (xi) Schooner Superannuation Fund, a Self-Managed Superannuation Fund registered with the Australian
Tax Office (ATO) under number 48 822 086 213 having its registered office at 1 Evans Court, Toorak, Victoria 3142,
Australia, (xii) Coonan Family Superannuation Fund, a Self-Managed Superannuation Fund registered with the Australian
Tax Office (ATO) under number 74 356 043 892 having its registered office at 9 Stone Street, Brighton East, Victoria
3187, Australia, (xiii) Paul4Viv Pty Limited, a Self-Managed Superannuation Fund registered with the Australian Tax Office
(ATO) under number 33 847 825 181 having its registered office at Unit 2, 25 Crimea Street, St Kilda, Victoria 3182,
Australia, (xiv) Mr. Gary Fairless Power, born on 14 April 1963 in Newcastle Upon Tyne (United Kingdom), residing at
46 Drummond Street, Greenvale, Melbourne, Victoria, 3059, Australia (xv) Mr. Jaime Pacreu Vizcaya, born on 18 January
1949 in Mexico D.F. (Mexico), residing at Avenue Fuente de Tritonos 34, Dep 1501, Lomas de Tecumachalco, Naucalpan
De Jaurez, Estado de Mexico, 53950, Mexico, (xvi) Mr. Malcolm Fallen, born on 26 October 1959 in Swindon (United
Kingdom), residing at Madleigh House, Village Road, Coleshill, Amersham, Buckimghamshire, HP7 0LQ, United Kingdom
and (xvii) Threewise Superannuation Fund, a Self-Managed Superannuation Fund registered with the Australian Tax Office
(ATO) under number 38 114 262 208 having its registered office at 39 Progress Road, Eltham North, Victoria 3095,
Australia, as new shareholders of the Company.
<i>Second resolution:i>
The general meeting of shareholders resolves to increase the Company's share capital by an amount of thirteen
thousand two hundred twenty euro and sixty cents (EUR 13,220.60) up to seventy-eight thousand seven hundred fifty-
two euro and sixty cents (EUR 78,752.60) through the issuance of (i) ten thousand one hundred fifty-eight (10,158) Class
A1 Shares, (ii) ten thousand one hundred fifty-eight (10,158) Class A2 Shares, (iii) ten thousand one hundred fifty-eight
(10,158) Class A3 Shares and (iv) ten thousand one hundred fifty-eight (10,158) Class A4 Shares, (v) twenty-nine thousand
six hundred ninety-five (29,695) Class B1 shares, (vi) twenty-nine thousand six hundred ninety-five (29,695) Class B2
shares, (vii) twenty-nine thousand six hundred ninety-five (29,695) Class B3 shares and (viii) twenty-nine thousand six
96257
L
U X E M B O U R G
hundred ninety-five (29,695) Class B4 shares and one hundred five thousand (105,000) Class C Shares all having a nominal
value of one cent (EUR 0.01) each.
(i) one thousand seven hundred eighty-six (1,786) Class A1 Shares, (ii) one thousand seven hundred eighty-six (1,786)
Class A2 Shares, (iii) one thousand seven hundred eighty-six (1,786) Class A3 Shares and (iv) one thousand seven hundred
eighty-six (1,786) class A4 Shares, (v) seven thousand seven hundred one (7,701) Class B1 shares, (vi) seven thousand
seven hundred one (7,701) Class B2 shares, (vii) seven thousand seven hundred one (7,701) Class B3 shares, (viii) seven
thousand seven hundred one (7,701) Class B4 shares and (ix) forty-six thousand (46,000) Class C shares and have been
entirely subscribed for a price of forty thousand two hundred forty-eight euro (EUR 40,248) by Mr. David George Beeby,
aforementioned, here represented by Ikrame Dabaj, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given by
way of a private instrument, and have been fully paid up by a contribution in kind of forty thousand two hundred forty-
eight (40,248) Fairfield 2 loan notes with a nominal value of one euro (EUR 1) each, held against the Company.
The proof of the existence and of the value of the above contribution has been produced to the undersigned notary.
The total contribution of forty thousand two hundred forty-eight euro (EUR 40,248) consists of four thousand one
hundred ninety-seven euro and forty cents (EUR 4,197.40) for the share capital and thirty-six thousand fifty euro and
sixty cents (EUR 36,050.60) for the share premium.
(i) eight hundred twenty-one (821) Class A1 Shares, (ii) eight hundred twenty-one (821) Class A2 Shares, (iii) eight
hundred twenty-one (821) Class A3 Shares and (iv) eight hundred twenty-one (821) Class A4 Shares have been entirely
subscribed for a price of three thousand two hundred eighty-four euro (EUR 3,284) by Mr. John Fell, aforementioned,
here represented by Ikrame Dabaj, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given by way of a private
instrument, and have been fully paid up by a contribution in kind of three thousand two hundred eighty-four (3,284)
Fairfield 2 loan notes with a nominal value of one euro (EUR 1) each, held against the Company.
The proof of the existence and of the value of the above contribution has been produced to the undersigned notary.
The total contribution of three thousand two hundred eighty-four euro (EUR 3,284) consists of four thousand one
hundred sixty-four euro and twenty cents (EUR 164.20) for the share capital and three thousand one hundred nineteen
euro and eighty cents (EUR 3119.80) for the share premium.
(i) four hundred eighty-three (483) Class A1 Shares, (ii) four hundred eighty-three (483) Class A2 Shares, (iii) four
hundred eighty-three (483) Class A3 Shares and (iv) four hundred eighty-three (483) class A4 Shares, (v) seven hundred
nineteen (719) Class B1 shares, (vi) seven hundred nineteen (719) Class B2 shares, (vii) seven hundred nineteen (719)
Class B3 shares and (viii) seven hundred nineteen (719) Class B4 shares have been entirely subscribed for a price of four
thousand eight hundred eight euro (EUR 4,808) by Mr. Wayne Middleton, aforementioned, here represented by Ikrame
Dabaj, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given by way of a private instrument, and have been
fully paid up by a contribution in kind of four thousand eight hundred eight (4,808) Fairfield 2 loan notes with a nominal
value of one euro (EUR 1) each, held against the Company.
The proof of the existence and of the value of the above contribution has been produced to the undersigned notary.
The total contribution of four thousand eight hundred eight euro (EUR 4,808) consists of two hundred forty euro and
forty cents (EUR 240.40) for the share capital and four thousand five hundred sixty-seven euro and sixty cents (EUR
4,567.60) for the share premium.
(i) five hundred forty-four (544) Class A1 Shares, (ii) five hundred forty-four (544) Class A2 Shares, (iii) five hundred
forty-four (544) Class A3 Shares and (iv) five hundred forty-four (544) class A4 Shares, (v) four thousand seven hundred
ninety-two (4,792) Class B1 shares, (vi) four thousand seven hundred ninety-two (4,792) Class B2 shares, (vii) four
thousand seven hundred ninety-two (4,792) Class B3 shares and (viii) four thousand seven hundred ninety-two (4,792)
Class B4 shares have been entirely subscribed for a price of twenty-one thousand three hundred forty-four euro (EUR
21,344) by Mr. Joseph James Piccione, aforementioned, here represented by Ikrame Dabaj, professionally residing in
Luxembourg, by virtue of a proxy, given by way of a private instrument, and have been fully paid up by a contribution in
kind of twenty-one thousand three hundred forty-four (21,344) Fairfield 2 loan notes with a nominal value of one euro
(EUR 1) each, held against the Company.
The proof of the existence and of the value of the above contribution has been produced to the undersigned notary.
The total contribution of twenty-one thousand three hundred forty-four euro (EUR 21,344) consists of one thousand
sixty-seven euro and twenty cents (EUR 1,067.20) for the share capital and twenty thousand two hundred seventy-six
euro and eighty cents (EUR 20,276.80) for the share premium.
(i) seven hundred eleven (711) Class A1 Shares, (ii) seven hundred eleven (711) Class A2 Shares, (iii) seven hundred
eleven (711) Class A3 Shares and (iv) seven hundred eleven (711) Class A4 Shares, (v) one thousand three hundred
eighteen (1,318) Class B1 shares, (vi) one thousand three hundred eighteen (1,318) Class B2 shares, (vii) one thousand
three hundred eighteen (1,318) Class B3 shares and (viii) one thousand three hundred eighteen (1,318) Class B4 shares
have been entirely subscribed for a price of eight thousand one hundred sixteen euro (EUR 8,116) by Mr. Ian Robinson,
aforementioned, here represented by Ikrame Dabaj, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given by
way of a private instrument, and have been fully paid up by a contribution in kind of eight thousand one hundred sixteen
(8,116) Fairfield 2 loan notes with a nominal value of one euro (EUR 1) each, held against the Company.
The proof of the existence and of the value of the above contribution has been produced to the undersigned notary.
96258
L
U X E M B O U R G
The total contribution of eight thousand one hundred sixteen euro (EUR 8,116) consists of four hundred five euro
and eighty cents (EUR 405.80) for the share capital and seven thousand seven hundred ten euro and twenty cents (EUR
7,710.20) for the share premium.
(i) seven hundred eleven (711) Class A1 Shares, (ii) seven hundred eleven (711) Class A2 Shares, (iii) seven hundred
eleven (711) Class A3 Shares and (iv) seven hundred eleven (711) Class A4 Shares, (v) one thousand three hundred
eighteen (1,318) Class B1 shares, (vi) one thousand three hundred eighteen (1,318) Class B2 shares, (vii) one thousand
three hundred eighteen (1,318) Class B3 shares and (viii) one thousand three hundred eighteen (1,318) Class B4 shares
have been entirely subscribed for a price of eight thousand one hundred sixteen euro (EUR 8,116) by Mr. Andrew Edward
Bayliff, aforementioned, here represented by Ikrame Dabaj, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy,
given by way of a private instrument, and have been fully paid up by a contribution in kind of eight thousand one hundred
sixteen (8,116) Fairfield 2 loan notes with a nominal value of one euro (EUR 1) each, held against the Company.
The proof of the existence and of the value of the above contribution has been produced to the undersigned notary.
The total contribution of eight thousand one hundred sixteen euro (EUR 8,116) consists of four hundred five euro
and eighty cents (EUR 405.80) for the share capital and seven thousand seven hundred ten euro and twenty cents (EUR
7,710.20) for the share premium.
(i) two hundred twenty-seven (227) Class A1 Shares, (ii) two hundred twenty-seven (227) Class A2 Shares, (iii) two
hundred twenty-seven (227) Class A3 Shares and (iv) two hundred twenty-seven (227) Class A4 Shares, (v) one thousand
three hundred eighteen (1,318) Class B1 shares, (vi) one thousand three hundred eighteen (1,318) Class B2 shares, (vii)
one thousand three hundred eighteen (1,318) Class B3 shares and (viii) one thousand three hundred eighteen (1,318)
Class B4 shares have been entirely subscribed for a price of six thousand one hundred eighty euro (EUR 6,180) by Mr.
George Wilson Allan, aforementioned, here represented by Ikrame Dabaj, professionally residing in Luxembourg, by
virtue of a proxy, given by way of a private instrument, and have been fully paid up by a contribution in kind of six thousand
one hundred eighty (6,180) Fairfield 2 loan notes with a nominal value of one euro (EUR 1) each, held against the Company.
The proof of the existence and of the value of the above contribution has been produced to the undersigned notary.
The total contribution of six thousand one hundred eighty euro (EUR 6,180) consists of three hundred nine euro (EUR
309) for the share capital and five thousand eight hundred seventy-one euro (EUR 5,871) for the share premium.
(i) three hundred forty-seven (347) Class A1 Shares, (ii) three hundred forty-seven (347) Class A2 Shares, (iii) three
hundred forty-seven (347) Class A3 Shares and (iv) three hundred forty-seven (347) Class A4 Shares, (v) one thousand
three hundred eighteen (1,318) Class B1 shares, (vi) one thousand three hundred eighteen (1,318) Class B2 shares, (vii)
one thousand three hundred eighteen (1,318) Class B3 shares and (viii) one thousand three hundred eighteen (1,318)
Class B4 shares have been entirely subscribed for a price of six thousand six hundred sixty euro (EUR 6,660) by Mr.
Dominic Mark Heaton, aforementioned, here represented by Ikrame Dabaj, professionally residing in Luxembourg, by
virtue of a proxy, given by way of a private instrument, and have been fully paid up by a contribution in kind of six thousand
six hundred sixty (6,660) Fairfield 2 loan notes with a nominal value of one euro (EUR 1) each, held against the Company.
The proof of the existence and of the value of the above contribution has been produced to the undersigned notary.
The total contribution of six thousand six hundred sixty euro (EUR 6,660) consists of three hundred thirty-three euro
(EUR 333) for the share capital and six thousand three hundred twenty-seven euro (EUR 6,327) for the share premium.
(i) eight hundred fourteen (814) Class A1 Shares, (ii) eight hundred fourteen (814) Class A2 Shares, (iii) eight hundred
fourteen (814) Class A3 Shares and (iv) eight hundred fourteen (814) Class A4 Shares, (v) one thousand three hundred
eighteen (1,318) Class B1 shares, (vi) one thousand three hundred eighteen (1,318) Class B2 shares, (vii) one thousand
three hundred eighteen (1,318) Class B3 shares and (viii) one thousand three hundred eighteen (1,318) Class B4 shares
have been entirely subscribed for a price of eight thousand five hundred twenty-eight euro (EUR 8,528) by Dmwake
Superannuation Fund, aforementioned, here represented by Ikrame Dabaj, professionally residing in Luxembourg, by
virtue of a proxy, given by way of a private instrument, and have been fully paid up by a contribution in kind of eight
thousand five hundred twenty-eight (8,528) Fairfield 2 loan notes with a nominal value of one euro (EUR 1) each, held
against the Company.
The proof of the existence and of the value of the above contribution has been produced to the undersigned notary.
The total contribution of eight thousand five hundred twenty-eight euro (EUR 8,528) consists of four hundred twenty-
six euro and forty cents (EUR 426.40) for the share capital and eight thousand one hundred one euro and sixty cents
(EUR 8,101.60) for the share premium.
(i) three hundred thirty-eight (338) Class A1 Shares, (ii) three hundred thirty-eight (338) Class A2 Shares, (iii) three
hundred thirty-eight (338) Class A3 Shares and (iv) three hundred thirty-eight (338) Class A4 Shares, (v) one thousand
three hundred eighteen (1,318) Class B1 shares, (vi) one thousand three hundred eighteen (1,318) Class B2 shares, (vii)
one thousand three hundred eighteen (1,318) Class B3 shares and (viii) one thousand three hundred eighteen (1,318)
Class B4 shares have been entirely subscribed for a price of six thousand six hundred twenty-four euro (EUR 6,624) by
I&F Stacey Pty Limited, aforementioned, here represented by Ikrame Dabaj, professionally residing in Luxembourg, by
virtue of a proxy, given by way of a private instrument, and have been fully paid up by a contribution in kind of six thousand
six hundred twenty-four (6,624) Fairfield 2 loan notes with a nominal value of one euro (EUR 1) each, held against the
Company.
96259
L
U X E M B O U R G
The proof of the existence and of the value of the above contribution has been produced to the undersigned notary.
The total contribution of six thousand six hundred twenty-four euro (EUR 6,624) consists of three hundred thirty-
one euro and twenty cents (EUR 331.20) for the share capital and six thousand two hundred ninety-two euro and eighty
cents (EUR 6,292.80) for the share premium.
(i) four hundred six (406) Class A1 Shares, (ii) four hundred six (406) Class A2 Shares, four hundred six (406) Class
A3 Shares and (iv) four hundred six (406) Class A4 Shares, (v) seven hundred nineteen (719) Class B1 shares, (vi) seven
hundred nineteen (719) Class B2 shares, (vii) seven hundred nineteen (719) Class B3 shares and (viii) seven hundred
nineteen (719) Class B4 shares have been entirely subscribed for a price of four thousand five hundred euro (EUR 4,500)
by Schooner Superannuation Fund, aforementioned, here represented by Ikrame Dabaj, professionally residing in Lu-
xembourg, by virtue of a proxy, given by way of a private instrument, and have been fully paid up by a contribution in
kind of four thousand five hundred (4,500) Fairfield 2 loan notes with a nominal value of one euro (EUR 1) each, held
against the Company.
The proof of the existence and of the value of the above contribution has been produced to the undersigned notary.
The total contribution of four thousand five hundred euro (EUR 4,500) consists of two hundred twenty-five euro (EUR
225) for the share capital and four thousand two hundred seventy-five euro (EUR 4,275) for the share premium.
(i) three hundred forty-five (345) Class A1 Shares, (ii) three hundred forty-five (345) Class A2 Shares, three hundred
forty-five (345) Class A3 Shares and (iv) three hundred forty-five (345) Class A4 Shares, (v) seven hundred nineteen (719)
Class B1 shares, (vi) seven hundred nineteen (719) Class B2 shares, (vii) seven hundred nineteen (719) Class B3 shares
and (viii) seven hundred nineteen (719) Class B4 shares have been entirely subscribed for a price of four thousand two
hundred fifty-six euro (EUR 4,256) by Coonan Family Superannuation Fund, aforementioned, here represented by Ikrame
Dabaj, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given by way of a private instrument, and have been
fully paid up by a contribution in kind of four thousand two hundred fifty-six (4,256) Fairfield 2 loan notes with a nominal
value of one euro (EUR 1) each, held against the Company.
The proof of the existence and of the value of the above contribution has been produced to the undersigned notary.
The total contribution of four thousand two hundred fifty-six euro (EUR 4,256) consists of two hundred twelve euro
and eighty cents (EUR 212.80) for the share capital and four thousand forty-three euro and twenty cents (EUR 4,043.20)
for the share premium.
(i) three hundred forty (340) Class A1 Shares, (ii) three hundred forty (340) Class A2 Shares, three hundred forty
(340) Class A3 Shares and (iv) three hundred forty (340) Class A4 Shares, (v) one thousand three hundred eighteen
(1,318) Class B1 shares, (vi) one thousand three hundred eighteen (1,318) Class B2 shares, (vii) one thousand three
hundred eighteen (1,318) Class B3 shares and (viii) one thousand three hundred eighteen (1,318) Class B4 shares have
been entirely subscribed for a price of six thousand six hundred thirty-two euro (EUR 6,632) by Paul4Viv Pty Limited,
aforementioned, here represented by Ikrame Dabaj, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given by
way of a private instrument, and have been fully paid up by a contribution in kind of six thousand six hundred thirty-two
(6,632) Fairfield 2 loan notes with a nominal value of one euro (EUR 1) each, held against the Company.
The proof of the existence and of the value of the above contribution has been produced to the undersigned notary.
The total contribution of six thousand six hundred thirty-two euro (EUR 6,632) consists of three hundred thirty-one
euro and sixty cents (EUR 331.60) for the share capital and six thousand three hundred euro and forty cents (EUR
6,300.40) for the share premium.
(i) two hundred sixteen (216) Class A1 Shares, (ii) two hundred sixteen (216) Class A2 Shares, two hundred sixteen
(216) Class A3 Shares and (iv) two hundred sixteen (216) Class A4 Shares, (v) one thousand three hundred eighteen
(1,318) Class B1 shares, (vi) one thousand three hundred eighteen (1,318) Class B2 shares, (vii) one thousand three
hundred eighteen (1,318) Class B3 shares and (viii) one thousand three hundred eighteen (1,318) Class B4 shares have
been entirely subscribed for a price of six thousand one hundred thirty-six euro (EUR 6,136) by Mr. Gary Fairless Power,
aforementioned, here represented by Ikrame Dabaj, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given by
way of a private instrument, and have been fully paid up by a contribution in kind of six thousand one hundred thirty-six
(6,136) Fairfield 2 loan notes with a nominal value of one euro (EUR 1) each, held against the Company.
The proof of the existence and of the value of the above contribution has been produced to the undersigned notary.
The total contribution of six thousand one hundred thirty-six (6,136) consists of three hundred six euro and eighty
cents (EUR 306.80) for the share capital and five thousand eight hundred twenty-nine euro and twenty cents (EUR
5,829.20) for the share premium.
(i) one hundred forty-one (141) Class A1 Shares, (ii) one hundred forty-one (141) Class A2 Shares, one hundred forty-
one (141) Class A3 Shares and (iv) one hundred forty-one (141) Class A4 Shares, (v) three hundred fifty-nine (359) Class
B1 shares, (vi) three hundred fifty-nine (359) Class B2 shares, (vii) three hundred fifty-nine (359) Class B3 shares and (viii)
three hundred fifty-nine (359) Class B4 shares have been entirely subscribed for a price of two thousand euro (EUR 2,000)
by Mr. Jaime Pacreu Vizcaya, aforementioned, here represented by Ikrame Dabaj, professionally residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy, given by way of a private instrument, and have been fully paid up by a contribution in kind of two
thousand (2,000) Fairfield 2 loan notes with a nominal value of one euro (EUR 1) each, held against the Company.
The proof of the existence and of the value of the above contribution has been produced to the undersigned notary.
96260
L
U X E M B O U R G
The total contribution of two thousand (2,000) consists of one hundred euro (EUR 100) for the share capital and one
thousand nine hundred euro (EUR 1,900) for the share premium.
(i) one thousand eight hundred twenty-one (1,821) Class A1 Shares, (ii) one thousand eight hundred twenty-one (1,821)
Class A2 Shares, one thousand eight hundred twenty-one (1,821) Class A3 Shares and (iv) one thousand eight hundred
twenty-one (1,821) Class A4 Shares, (v) three thousand four hundred twenty-three (3,423) Class B1 shares, (vi) three
thousand four hundred twenty-three (3,423) Class B2 shares, (vii) three thousand four hundred twenty-three (3,423)
Class B3 shares, (viii) three thousand four hundred twenty-three (3,423) Class B4 shares and fifty-nine thousand (59,000)
Class C shares have been entirely subscribed for a price of twenty-three thousand nine hundred twenty-six euro (EUR
23,926) by Mr. Malcolm Fallen, aforementioned, here represented by Ikrame Dabaj, professionally residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy, given by way of a private instrument, and have been fully paid up by a contribution in kind of twenty-
three thousand nine hundred twenty-six (23,926) Fairfield 2 loan notes with a nominal value of one euro (EUR 1) each,
held against the Company.
The proof of the existence and of the value of the above contribution has been produced to the undersigned notary.
The total contribution of twenty-three thousand nine hundred twenty-six euro (EUR 23,926) consists of three thou-
sand nine hundred ninety-eight euro and eighty cents (EUR 3,998.80) for the share capital and nineteen thousand nine
hundred twenty-seven euro and twenty cents (EUR 19,927.20) for the share premium.
(i) one hundred seven (107) Class A1 Shares, (ii) one hundred seven (107) Class A2 Shares, one hundred seven (107)
Class A3 Shares and (iv) one hundred seven (107) Class A4 Shares, (v) seven hundred nineteen (719) Class B1 shares,
(vi seven hundred nineteen (719) Class B2 shares, (vii) seven hundred nineteen (719) Class B3 shares and (viii) seven
hundred nineteen (719) Class B4 shares have been entirely subscribed for a price of three thousand three hundred four
euro (EUR 3,304) by Threewise Superannuation Fund, aforementioned, here represented by Ikrame Dabaj, professionally
residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given by way of a private instrument, and have been fully paid up by a
contribution in kind of three thousand three hundred four (3,304) Fairfield 2 loan notes with a nominal value of one euro
(EUR 1) each, held against the Company.
The proof of the existence and of the value of the above contribution has been produced to the undersigned notary.
The total contribution of three thousand three hundred four euro (EUR 3,304) consists of three thousand nine hundred
ninety-eight euro and eighty cents (EUR 165.20) for the share capital and three thousand one hundred thirty-eight euro
and eighty cents (EUR 3,138.80) for the share premium.
- Mr. David George Beeby,
- Mr. John Fell,
- Mr. Wayne Middleton,
- Mr. Joseph James Piccione,
- Mr. Ian Robinson,
- Mr. Andrew Edward Bayliff,
- Mr. George Wilson Allan,
- Mr. Dominic Mark Heaton,
- Dmwake Superannuation Fund,
- I&F Stacey Pty Limited,
- Schooner Superannuation Fund,
- Coonan Family Superannuation Fund,
- Paul4Viv Pty Limited,
- Mr. Gary Fairless Power,
- Mr. Jaime Pacreu Vizcaya,
- Mr. Malcolm Fallen, and
- Threewise Superannuation Fund,
All aforementioned, all here represented by Ikrame Dabaj, professionally residing in Luxembourg, by virtue of proxies,
here attached,
join the general meeting of shareholders of the Company and resolve together with Fairfield L.P. on the subsequent
items of the agenda.
<i>Third resolution:i>
As a consequence of the above resolutions, the general meeting of shareholders resolves to amend article 5.1of the
Company's articles of association which shall henceforth read as follows:
The Company's share capital is set at seventy-eight thousand seven hundred fifty-two euro and sixty cents (EUR
78,752.60), consisting of the following shares:
(i) two hundred eighty-seven thousand five hundred one (287,501) class A1 shares with a nominal value of one cent
(EUR 0.01) each (the “Class A1 Shares”);
96261
L
U X E M B O U R G
(ii) two hundred eighty-seven thousand five hundred one (287,501) class A2 shares with a nominal value of one cent
(EUR 0.01) each (the “Class A2 Shares”);
(iii) two hundred eighty-seven thousand five hundred one (287,501) class A3 shares with a nominal value of one cent
(EUR 0.01) each (the “Class A3 Shares”);
(iv) two hundred eighty-seven thousand five hundred one (287,501) class A4 shares with a nominal value of one cent
(EUR 0.01) each (the “Class A4 Shares” and, together with the Class A1 Shares, the Class A2 Shares and the Class A3
Shares the "Class A Shares" and the holders thereof are referred to collectively as "A Shareholders");
(v) fifty-four thousand seven hundred sixty-two (54,762) class B1 shares with a nominal value of one cent (EUR 0.01)
each (the “Class B1 Shares”);
(vi) fifty-four thousand seven hundred sixty-two (54,762) class B2 shares with a nominal value of one cent (EUR 0.01)
each (the “Class B2 Shares”);
(vii) fifty-four thousand seven hundred sixty-two (54,762) class B3 shares with a nominal value of one cent (EUR 0.01)
each (the “Class B3 Shares”);
(viii) fifty-four thousand seven hundred sixty-two (54,762) class B4 shares with a nominal value of one cent (EUR 0.01)
each (the “Class B4 Shares” and, together with the Class B1 Shares, the Class B2 Shares and the Class B3 Shares the
"Class B Shares" and the holders thereof are referred to collectively as "B Shareholders"); and
(ix) two hundred six thousand (206,000) class C shares with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each (the “Class
C Shares” and the holders thereof are referred to collectively as "C Shareholders").
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be
borne by the Company in connection with the present deed are estimated at approximately EUR 2,800.-.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-
ment.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,
this deed is worded in English followed by a French translation; at the request of the same appearing parties and in case
of divergence between the English and the French text, the English version shall prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name
and residence, the said proxyholder of the appearing parties signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède
L'an deux mille quatorze, le vingt-huit avril.
Par-devant nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
ONT COMPARU:
1) Fairfield L.P., un limited partnership existant selon les lois de Guernsey, immatriculé sous le numéro 2042, ayant
son siège social au PO Box 255, Trafalgar Court, Les Banques, St. Peter Port, Guernsey GY1 3 QL («Fairfield L.P.»),
détenteur de deux cent soixante-seize mille huit cent quatre-vingts (276.880) Parts Sociales de Catégorie A1, (ii) deux
cent soixante-seize mille huit cent quatre-vingts (276.880) Parts Sociales de Catégorie A2, (iii) deux cent soixante-seize
mille huit cent quatre-vingts (276.880) Parts Sociales de Catégorie A3 et (iv) deux cent soixante-seize mille huit cent
quatre-vingts (276.880) Parts Sociales de Catégorie A4,
ici représenté par Ikrame Dabaj, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée par
acte sous-seing privé,
2) M. Barend Franciscus Johannes van den Hoek, né le 27 décembre 1957 à Zierikzee (Pays-Bas), résidant au 4 Boyd
Close, Mooroolbark, Victoria, 3138 Australie, détenteur de (i) cent soixante-et-onze (171) Parts Sociales de Catégorie
A1, (ii) cent soixante-et-onze (171) Parts Sociales de Catégorie A2, (iii) cent soixante-et-onze (171) Parts Sociales de
Catégorie A3, (iv) cent soixante-et-onze (171) Parts Sociales de Catégorie A4, (v) huit cent trente-neuf (839) Parts Sociales
de Catégorie B1, (vi) huit cent trente-neuf (839) Parts Sociales de Catégorie B2, (vii) huit cent trente-neuf (839) Parts
Sociales de Catégorie B3 et (viii) huit cent trente-neuf (839) Parts Sociales de Catégorie B4,
ici représenté par Ikrame Dabaj, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée par
acte sous-seing privé,
3) M. Andrew Michael Copson, né le 21 octobre 1963 à Aldershot (Royaume-Uni), résidant à 6, Westport Manor,
Gastons Road, Malmesbury, SN16 0FE, Royaume-Uni, détenteur de (i) cent trente-deux (132) Parts Sociales de Catégorie
A1, (ii) cent trente-deux (132) Parts Sociales de Catégorie A2, (iii) cent trente-deux (132) Parts Sociales de Catégorie
A3, (iv) cent trente-deux (132) Parts Sociales de Catégorie A4, (v) mille trois cent dix-huit (1.318) Parts Sociales de
Catégorie B1, (vi) mille trois cent dix-huit (1.318) Parts Sociales de Catégorie B2, (vii) mille trois cent dix-huit (1.318)
Parts Sociales de Catégorie B3 et (viii) mille trois cent dix-huit (1.318) Parts Sociales de Catégorie B4,
ici représenté par Ikrame Dabaj, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée par
acte sous-seing privé,
96262
L
U X E M B O U R G
4) S&L Casey Superannuation Fund, un Superannuation Fund autogéré immatriculé auprès du Australian Tax Office
(ATO) sous le numéro 13 689 063 228, ayant son siège social au 2/322 Cotham Road, Kew Victoria 3101, Australie,
détenteur de (i) cent soixante (160)Parts Sociales de Catégorie A1,(ii) cent soixante (160) Parts Sociales de Catégorie
A2, (iii) cent soixante (160) Parts Sociales de Catégorie A3, (iv) cent soixante (160) Parts Sociales de Catégorie A4, (v)
sept cent dix-neuf (719) Parts Sociales de Catégorie B1, (vi) sept cent dix-neuf (719) Parts Sociales de Catégorie B2, (vii)
sept cent dix-neuf (719) Parts Sociales de Catégorie B3, (viii) sept cent dix-neuf (719) Parts Sociales de Catégorie B4,
ici représenté par Ikrame Dabaj, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée par
acte sous-seing privé,
5) Fairfield 2014 Employee Benefit Trust, un trust constitué selon les lois de Jersey et selon un trust instrument daté
du 23 avril 2014 entre Appleby Trust (Jersey) Limited constitué et enregistré à Jersey sous le numéro 21755 ayant son
siège social au 13-14 Esplanade, St Helier, Jersey, JE1 1BD (comme trustee) et Fairfield Bidco Limited (comme settlor),
détenteur de (i) vingt-deux mille cent quatre-vingt-onze (22.191) Parts Sociales de Catégorie B1, (ii) vingt-deux mille cent
quatre-vingt-onze (22.191) Parts Sociales de Catégorie B2, (iii) vingt-deux mille cent quatre-vingt-onze (22.191) Parts
Sociales de Catégorie B3, (iv) vingt-deux mille cent quatre-vingt-onze (22.191) Parts Sociales de Catégorie B4 et (v) cent
un mille (101.000) Parts Sociales de Catégorie C,
ici représenté par Ikrame Dabaj, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée par
acte sous-seing privé,
Lesdites procurations, paraphées ne varietur par la mandataire des parties comparantes et par le notaire, resteront
annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités d'enregistrement.
Lesquelles parties comparantes sont les associés de Fairfield 1 S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée
et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 46A avenue J.F. Kennedy, L-1855
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 185390, constituée selon acte reçu par Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 5 mars 2014, non encore publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations (ci-après la «Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois selon acte
reçu par le notaire soussigné en date du 25 avril 2014, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
Les parties comparantes représentant l'intégralité du capital social ont requis le notaire soussigné d'acter que l'ordre
du jour de l'assemblée sera le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Acceptation de M. David George Beeby, M. John Fell, M. Wayne Middleton, M. Joseph James Piccione, M. Ian
Robinson, M. Andrew Edward Bayliff, M. George Wilson Allan, M. Dominic Mark Heaton, Dmwake Superannuation Fund,
I&F Stacey Pty Limited, Schooner Superannuation Fund, Coonan Family Superannuation Fund, Paul4Viv Pty Limited, M.
Gary Fairless Power, Mr Jaime Pacreu Vizcaya, M. Malcolm Fallen and Threewise Superannuation Funden tant que nou-
veaux associés de la Société.
2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de treize mille deux cent vingt euros et soixante cents
(EUR 13.220,60) jusqu'à soixante-dix-huit mille sept cent cinquante-deux euros et soixante cents (EUR 78.752,60) par
l'émission de (i) dix mille cent cinquante-huit (10.158) Parts Sociales de Catégorie A1, (ii) dix mille cent cinquante-huit
(10.158) Parts Sociales de Catégorie A2, (iii) dix mille cent cinquante-huit (10.158) Parts Sociales de Catégorie A3, (iv)
dix mille cent cinquante-huit (10.158) Parts Sociales de Catégorie A4, (v) vingt-neuf mille six cent quatre-vingt-quinze
(29.695) Parts Sociales de Catégorie B1, (vi) vingt-neuf mille six cent quatre-vingt-quinze (29.695) Parts Sociales de Ca-
tégorie B2, (vii) vingt-neuf mille six cent quatre-vingt-quinze (29.695) Parts Sociales de Catégorie B3 et (viii) vingt-neuf
mille six cent quatre-vingt-quinze (29.695) Parts Sociales de Catégorie B4 et (ix) cent cinq mille (105.000) Parts Sociales
de Catégorie C, d'une valeur nominale de cinq cents (EUR 0,05) chacune;
3. Décision de modifier l'article 5.1 des statuts de la Société;
4. Divers.
Lesquelles parties comparantes représentant l'intégralité du capital social, ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale des associés décide d'accepter (i) M. David George Beeby, né le 11 août 1952 à Nottingham
(Royaume-Uni), résidant à The Ghyll, Cockermouth, Cumbria, CA13 0NY, Royaume-Uni, (ii) M. John Fell, né le 4 mai
1956 à Carlisle, Cumbria (Royaume-Uni), résidant à Glynsdale Cottage, Aikhead, Cumbria, CA7 0EJ, Royaume-Uni, (iii)
M. Wayne Middleton, né le 15 février 1969 à Carlisle, Cumbria (Royaume-Uni), résidant à Midtown Barn, High Brigham,
Cockermouth, Cumbria, CA13 0TB, Royaume-Uni, (iv) M. Joseph James Piccione, né le 28 octobre 1961 à Columbus,
Ohio (Etats-Unis d'Amérique), résidant au 2901 Perrington Way, Maritetta, GA, 30066, Etats-Unis d'Amérique, (v) M.
Ian Robinson, né le 7 février 1959 à Portsmouth (Royaume-Uni), résidant à Holme View, High Bridge, Dalston, Carlisle,
CA5 7DR, Royaume-Uni, (vi) M. Andrew Edward Bayliff, né le 16 février 1961 à Ulverston, Cumbria (Royaume-Uni),
résidant à Vale House, Curthwaite, Wigton, Cumbria, CA7 8BG, Royaume-Uni, (vii) M. George Wilson Allan, né le 3
janvier 1963 in Glasgow (Ecosse), résidant à Linsum, Beaumont, Carlisle, CA5 6EF, Royaume-Uni, (viii) M. Dominic Mark
96263
L
U X E M B O U R G
Heaton, né le 14 septembre 1972 à Oxford (Royaume-Uni), résidant au 2 Holmewood Paddock, Cockermouth, Cumbria,
CA13 0AN, Royaume-Uni, (ix) Dmwake Superannuation Fund, un Superannuation Fund auto-géré immatriculé auprès du
Australian Tax Office (ATO) sous le numéro 18 317 077 316,dont le siège social est sis à Multiport Level 1, 1 Chifley
Square, Sydney, NSW 2000, Australie, (x) I&F Stacey Pty Limited, un Superannuation Fund auto-géré immatriculé auprès
du Australian Tax Office (ATO) sous le numéro 28 605 532 768 dont le siège social est sis au 11 York Street, St Kilda
West, Melbourne, Victoria 3182, Australie, (xi) Schooner Superannuation Fund un Superannuation Fund auto-géré im-
matriculé auprès du Australian Tax Office (ATO) sous le numéro 48 822 086 213 dont le siège social est sis au 1 Evans
Court, Toorak, Victoria, 3142, Australie, (xii) Coonan Family Superannuation Fund un Superannuation Fund auto-géré
immatriculé auprès du Australian Tax Office (ATO) sous le numéro 74 356 043 892 dont le siège social est au 9 Stone
Street, Brighton East, Victoria 3187, Australia, (xiii) Paul4Viv Pty Limited, un Superannuation Fund auto-géré immatriculé
auprès du Australian Tax Office (ATO) sous le numéro 33 847 825 181 dont le siège social est au Unit 2, 25 Crimea
Street, St Kilda, Victoria, 3182, Australie, (xiv) M. Gary Fairless Power, né le 14 Avril 1963 à Newcastle Upon Tyne
(Royaume-Uni), résidant au 46 Drummond Street, Greenvale, Melbourne, Victoria, 3059, Australia, (xv) M. Jaime Pacreu
Vizcaya, né le 18 Janvier 1949 à Mexico D.F. (Mexico), résidant à avenue Fuente de Tritonos 34, Dep 1501, Lomas de
Tecumachalco, Naucalpan De Jaurez, Estado de Mexico, 53950, Mexico, (xvi) M. Malcolm Fallen, né le 26 octobre 1959
à Swindon (Royaume-Uni), résidant à Madleigh House, Village Road, Coleshill, Amersham, Buckimghamshire, HP7 0LQ,
Royaume-Uni et (xvii) Threewise Superannuation Fund un Superannuation Fund auto-géré immatriculé auprès du Aus-
tralian Tax Office (ATO) sous le numéro 38 114 262 208 dont le siège social est sis au, 39 Progress Road, Eltham North,
Victoria 3095, Australie en tant que nouveaux associés de la Société.
<i>Seconde résolutioni>
L'assemblée générale des associés décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de treize mille deux
cent vingt euros et soixante cents (EUR 13.220,60) jusqu'à soixante-dix-huit mille sept cent cinquante-deux euros et
soixante cents (EUR 78.752,60) par l'émission de (i) dix mille cent cinquante-huit (10.158) Parts Sociales de Catégorie
A1, (ii) dix mille cent cinquante-huit (10.158) Parts Sociales de Catégorie A2, (iii) dix mille cent cinquante-huit (10.158)
Parts Sociales de Catégorie A3, (iv) dix mille cent cinquante-huit (10.158) Parts Sociales de Catégorie A4, (v) vingt-neuf
mille six cent quatre-vingt-quinze (29.695) Parts Sociales de Catégorie B1, (vi) vingt-neuf mille six cent quatre-vingt-quinze
(29.695) Parts Sociales de Catégorie B2, (vii) vingt-neuf mille six cent quatre-vingt-quinze (29.695) Parts Sociales de
Catégorie B3 et (viii) vingt-neuf mille six cent quatre-vingt-quinze (29.695) Parts Sociales de Catégorie B4 et (ix) cent
cinq mille (105.000) Parts Sociales de Catégorie C, d'une valeur nominale de cinq cents (EUR 0,05) chacune.
(i) mille sept cent quatre-vingt-six (1.786) Parts Sociales de Catégorie A1, (ii) mille sept cent quatre-vingt-six (1.786)
Parts Sociales de Catégorie A2, (iii) mille sept cent quatre-vingt-six (1.786) Parts Sociales de Catégorie A3, (iv) mille sept
cent quatre-vingt-six (1.786) Parts Sociales de Catégorie A4, (v) sept mille sept cent une (7.701) Parts Sociales de Caté-
gorie B1, (vi) sept mille sept cent une (7.701) Parts Sociales de Catégorie B2, (vii) sept mille sept cent une (7.701) Parts
Sociales de Catégorie B3, (viii) sept mille sept cent une (7.701) Parts Sociales de Catégorie B4 et quarante-six mille
(46.000) Parts Sociales de Catégorie C ont été entièrement souscrites par M. David George Beeby, susmentionné, ici
représenté par Ikrame Dabaj, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée par acte
sous-seing privé, pour un prix de quarante mille deux cent quarante-huit euros (EUR 40.248) et ont été intégralement
libérées par un apport en nature consistant en quarante mille deux cent quarante-huit (40.248) obligations émises par
Fairfield 2 d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, détenues à l'encontre de la Société.
La preuve de l'existence et de la valeur de cet apport a été produite au notaire soussigné.
L'apport global d'un montant de quarante mille deux cent quarante-huit euros (EUR 40.248) consiste en quatre mille
cent quatre-vingt-dix-sept euros et quarante cents (EUR 4.197,40) pour le capital social et trente-six mille cinquante euros
et soixante cents (EUR 36.050,60) pour la prime d'émission.
(i) huit cent vingt-et-une (821) Parts Sociales de Catégorie A1, (ii) huit cent vingt-et-une (821) Parts Sociales de Ca-
tégorie A2, (iii) huit cent vingt-et-une (821) Parts Sociales de Catégorie A3 et (iv) huit cent vingt-et-une (821) Parts
Sociales de Catégorie A4, ont été entièrement souscrites par M. John Fell, susmentionné, ici représenté par Ikrame Dabaj,
résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée par acte sous-seing privé, pour un prix
de trois mille deux cent quatre-vingt-quatre euros (EUR 3.284) et ont été intégralement libérées par un apport en nature
consistant en trois mille deux cent quatre-vingt-quatre (3.284) obligations émises par Fairfield 2 d'une valeur nominale
d'un euro (EUR 1) chacune, détenues à l'encontre de la Société.
La preuve de l'existence et de la valeur de cet apport a été produite au notaire soussigné.
L'apport global d'un montant de trois mille deux cent quatre-vingt-quatre euros (EUR 3.284) consiste en cent soixante-
quatre euros et vingt cents (EUR 164,20) pour le capital social et trois mille cent dix-neuf euros et quatre-vingts cents
(EUR 3.119,80) pour la prime d'émission.
(i) quatre cent quatre-vingt-trois (483) Parts Sociales de Catégorie A1, (ii) quatre cent quatre-vingt-trois (483) Parts
Sociales de Catégorie A2, (iii) quatre cent quatre-vingt-trois (483) Parts Sociales de Catégorie A3, (iv) quatre cent quatre-
vingt-trois (483) Parts Sociales de Catégorie A4, (v) sept cent dix-neuf (719) Parts Sociales de Catégorie B1, (vi) sept cent
dix-neuf (719) Parts Sociales de Catégorie B2, (vii) sept cent dix-neuf (719) Parts Sociales de Catégorie B3 et (viii) sept
cent dix-neuf (719) Parts Sociales de Catégorie B4 ont été entièrement souscrites par M. Wayne Middleton, susmentionné,
ici représenté par Ikrame Dabaj, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée par
96264
L
U X E M B O U R G
acte sous-seing privé, pour un prix de quatre mille huit cent huit euros (EUR 4.808) et ont été intégralement libérées par
un apport en nature consistant en quatre mille huit cent huit (4.808) obligations émises par Fairfield 2 d'une valeur nominale
d'un euro (EUR 1) chacune, détenues à l'encontre de la Société.
La preuve de l'existence et de la valeur de cet apport a été produite au notaire soussigné.
L'apport global d'un montant de quatre mille huit cent huit euros (EUR 4.808) consiste en deux cent quarante euros
et quarante cents (EUR 240,40) pour le capital social et quatre mille cinq cent soixante-sept euros et soixante cents (EUR
4.567,60) pour la prime d'émission.
(i) cinq cent quarante-quatre (544) Parts Sociales de Catégorie A1, (ii) cinq cent quarante-quatre (544) Parts Sociales
de Catégorie A2, (iii) cinq cent quarante-quatre (544) Parts Sociales de Catégorie A3, (iv) cinq cent quarante-quatre (544)
Parts Sociales de Catégorie A4, (v) quatre mille sept cent quatre-vingt-douze (4.792) Parts Sociales de Catégorie B1, (vi)
quatre mille sept cent quatre-vingt-douze (4.792) Parts Sociales de Catégorie B2, (vii) quatre mille sept cent quatre-vingt-
douze (4.792) Parts Sociales de Catégorie B3 et (viii) quatre mille sept cent quatre-vingt-douze (4.792) Parts Sociales de
Catégorie B4 ont été entièrement souscrites par M. Joseph James Piccione, susmentionné, ici représenté par Ikrame
Dabaj, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée par acte sous-seing privé, pour
un prix de vingt-et-un mille trois cent quarante-quatre euros (EUR 21.344) et ont été intégralement libérées par un apport
en nature consistant en vingt-et-un mille trois cent quarante-quatre (21.344) obligations émises par Fairfield 2 d'une valeur
nominale d'un euro (EUR 1) chacune, détenues à l'encontre de la Société.
La preuve de l'existence et de la valeur de cet apport a été produite au notaire soussigné.
L'apport global d'un montant de vingt-et-un mille trois cent quarante-quatre euros (EUR 21.344) consiste en mille
soixante-sept euros et vingt cents (EUR 1.067,20) pour le capital social et vingt mille deux cent soixante-seize euros et
quatre-vingt cents(EUR 20.276,80) pour la prime d'émission.
(i) sept cent onze (711) Parts Sociales de Catégorie A1, (ii) sept cent onze (711) Parts Sociales de Catégorie A2, (iii)
sept cent onze (711) Parts Sociales de Catégorie A3, (iv) sept cent onze (711) Parts Sociales de Catégorie A4, (v) mille
trois cent dix-huit (1.318) Parts Sociales de Catégorie B1, (vi) mille trois cent dix-huit (1.318) Parts Sociales de Catégorie
B2, (vii) mille trois cent dix-huit (1.318) Parts Sociales de Catégorie B3 et (viii) mille trois cent dix-huit (1.318) Parts
Sociales de Catégorie B4 ont été entièrement souscrites par M. Ian Robinson, susmentionné, ici représenté par Ikrame
Dabaj, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée par acte sous-seing privé, pour
un prix de huit mille cent seize euros (EUR 8.116) et ont été intégralement libérées par un apport en nature consistant
en huit mille cent seize (8.116) obligations émises par Fairfield 2 d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune,
détenues à l'encontre de la Société.
La preuve de l'existence et de la valeur de cet apport a été produite au notaire soussigné.
L'apport global d'un montant de huit mille cent seize euros (EUR 8.116) consiste en quatre cent cinq euros et quatre-
vingt cents (EUR 405,80) pour le capital social et sept mille sept cent dix euros et vingt cents (EUR 7.710,20) pour la
prime d'émission.
(i) sept cent onze (711) Parts Sociales de Catégorie A1, (ii) sept cent onze (711) Parts Sociales de Catégorie A2, (iii)
sept cent onze (711) Parts Sociales de Catégorie A3, (iv) sept cent onze (711) Parts Sociales de Catégorie A4, (v) mille
trois cent dix-huit (1.318) Parts Sociales de Catégorie B1, (vi) mille trois cent dix-huit (1.318) Parts Sociales de Catégorie
B2, (vii) mille trois cent dix-huit (1.318) Parts Sociales de Catégorie B3 et (viii) mille trois cent dix-huit (1.318) Parts
Sociales de Catégorie B4 ont été entièrement souscrites par M. Andrew Edward Bayliff, susmentionné, ici représenté par
Ikrame Dabaj, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée par acte sous-seing privé,
pour un prix de huit mille cent seize euros (EUR 8.116) et ont été intégralement libérées par un apport en nature consistant
en huit mille cent seize (8.116) obligations émises par Fairfield 2 d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune,
détenues à l'encontre de la Société.
La preuve de l'existence et de la valeur de cet apport a été produite au notaire soussigné.
L'apport global d'un montant de huit mille cent seize euros (EUR 8.116) consiste en quatre cent cinq euros et quatre-
vingt cents (EUR 405,80) pour le capital social et sept mille sept cent dix euros et vingt cents (EUR 7.710,20) pour la
prime d'émission.
(i) deux-cent vingt-sept (227) Parts Sociales de Catégorie A1, (ii) deux-cent vingt-sept (227) Parts Sociales de Catégorie
A2, (iii) deux-cent vingt-sept (227) Parts Sociales de Catégorie A3, (iv) deux-cent vingt-sept (227) Parts Sociales de
Catégorie A4, (v) mille trois cent dix-huit (1.318) Parts Sociales de Catégorie B1, (vi mille trois cent dix-huit (1.318) Parts
Sociales de Catégorie B2, (vii) mille trois cent dix-huit (1.318) Parts Sociales de Catégorie B3 et (viii) mille trois cent dix-
huit (1.318) Parts Sociales de Catégorie B4 ont été entièrement souscrites par M. George Wilson Allan, susmentionné,
ici représenté par Ikrame Dabaj, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée par
acte sous-seing privé, pour un prix de six mille cent quatre-vingts euros (EUR 6.180) et ont été intégralement libérées
par un apport en nature consistant en six mille cent quatre-vingts (6.180) obligations émises par Fairfield 2 d'une valeur
nominale d'un euro (EUR 1) chacune, détenues à l'encontre de la Société.
La preuve de l'existence et de la valeur de cet apport a été produite au notaire soussigné.
L'apport global d'un montant de six mille cent quatre-vingts euros (EUR 6.180) consiste en trois cent neuf euros (EUR
309) pour le capital social et cinq mille huit cent soixante-et-onze euros (EUR 5.871) pour la prime d'émission.
96265
L
U X E M B O U R G
(i) trois cent quarante-sept (347) Parts Sociales de Catégorie A1, (ii) trois cent quarante-sept (347) Parts Sociales de
Catégorie A2, (iii) trois cent quarante-sept (347) Parts Sociales de Catégorie A3, (iv) trois cent quarante-sept (347) Parts
Sociales de Catégorie A4, (v) mille trois cent dix-huit (1.318) Parts Sociales de Catégorie B1, (vi) mille trois cent dix-huit
(1.318) Parts Sociales de Catégorie B2, (vii) mille trois cent dix-huit (1.318) Parts Sociales de Catégorie B3 et (viii) mille
trois cent dix-huit (1.318) Parts Sociales de Catégorie B4 ont été entièrement souscrites par M. Dominic Mark Heaton,
susmentionné, ici représenté par Ikrame Dabaj, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration
donnée par acte sous-seing privé, pour un prix de six mille six cent soixante euros (EUR 6.660) et ont été intégralement
libérées par un apport en nature consistant en six mille six cent soixante (6.660) obligations émises par Fairfield 2 d'une
valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, détenues à l'encontre de la Société.
La preuve de l'existence et de la valeur de cet apport a été produite au notaire soussigné.
L'apport global d'un montant de six mille six cent soixante euros (EUR 6.660) consiste en trois cent trente-trois euros
(EUR 333) pour le capital social et six mille trois cent vingt-sept euros (EUR 6.327) pour la prime d'émission.
(i) huit cent quatorze (814) Parts Sociales de Catégorie A1, (ii) huit cent quatorze (814) Parts Sociales de Catégorie
A2, (iii) huit cent quatorze (814) Parts Sociales de Catégorie A3, (iv) huit cent quatorze (814) Parts Sociales de Catégorie
A4, (v) mille trois cent dix-huit (1.318) Parts Sociales de Catégorie B1, (vi) mille trois cent dix-huit (1.318) Parts Sociales
de Catégorie B2, (vii) mille trois cent dix-huit (1.318) Parts Sociales de Catégorie B3 et (viii) mille trois cent dix-huit
(1.318) Parts Sociales de Catégorie B4 ont été entièrement souscrites par Dmwake Superannuation Fund, susmentionné,
ici représenté par Ikrame Dabaj, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée par
acte sous-seing privé, pour un prix de huit mille cinq cent vingt-huit euros (EUR 8.528) et ont été intégralement libérées
par un apport en nature consistant en huit mille cinq cent vingt-huit (8.528) obligations émises par Fairfield 2 d'une valeur
nominale d'un euro (EUR 1) chacune, détenues à l'encontre de la Société.
La preuve de l'existence et de la valeur de cet apport a été produite au notaire soussigné.
L'apport global d'un montant de huit mille cinq cent vingt-huit euros (EUR 8.528) consiste en quatre cent vingt-six
euros et quarante cents (EUR 426,40) pour le capital social et huit mille cent un euros et soixante cents (EUR 8.101,60)
pour la prime d'émission.
(i) trois cent trente-huit (338) Parts Sociales de Catégorie A1, (ii) trois cent trente-huit (338) Parts Sociales de Caté-
gorie A2, (iii) trois cent trente-huit (338) Parts Sociales de Catégorie A3, (iv) trois cent trente-huit (338) Parts Sociales
de Catégorie A4, (v) mille trois cent dix-huit (1.318) Parts Sociales de Catégorie B1, (vi) mille trois cent dix-huit (1.318)
Parts Sociales de Catégorie B2, (vii) mille trois cent dix-huit (1.318) Parts Sociales de Catégorie B3 et (viii) mille trois
cent dix-huit (1.318) Parts Sociales de Catégorie B4 ont été entièrement souscrites par I&F Stacey Pty Limited, susmen-
tionné, ici représenté par Ikrame Dabaj, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée
par acte sous-seing privé, pour un prix de six mille six cent vingt-quatre euros (EUR 6.624) et ont été intégralement
libérées par un apport en nature consistant en six mille six cent vingt-quatre (6.624) obligations émises par Fairfield 2
d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, détenues à l'encontre de la Société.
La preuve de l'existence et de la valeur de cet apport a été produite au notaire soussigné.
L'apport global d'un montant de six mille six cent vingt-quatre euros (EUR 6.624) consiste en trois cent trente-et-un
euros et vingt cents (EUR 331,20) pour le capital social et six mille deux cent quatre-vingt-douze euros et quatre-vingt
cents (EUR 6.292,80) pour la prime d'émission.
(i) quatre cent six (406) Parts Sociales de Catégorie A1, (ii) quatre cent six (406) Parts Sociales de Catégorie A2, (iii)
quatre cent six (406) Parts Sociales de Catégorie A3, (iv) quatre cent six (406) Parts Sociales de Catégorie A4, (v) sept
cent dix-neuf (719) Parts Sociales de Catégorie B1, (vi) sept cent dix-neuf (719) Parts Sociales de Catégorie B2, (vii) sept
cent dix-neuf (719) Parts Sociales de Catégorie B3 et (viii) sept cent dix-neuf (719) Parts Sociales de Catégorie B4 ont
été entièrement souscrites par Schooner Superannuation Fund, susmentionné, ici représenté par Ikrame Dabaj, résidant
professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée par acte sous-seing privé, pour un prix de quatre
mille cinq cents euros (EUR 4.500) et ont été intégralement libérées par un apport en nature consistant en quatre mille
cinq cents (4.500) obligations émises par Fairfield 2 d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, détenues à l'en-
contre de la Société.
La preuve de l'existence et de la valeur de cet apport a été produite au notaire soussigné.
L'apport global d'un montant de quatre mille cinq cents euros (EUR 4.500) consiste en deux cent vingt-cinq euros
(EUR 225) pour le capital social et quatre mille deux cent soixante-quinze euros (EUR 4.275) pour la prime d'émission.
(i) trois cent quarante-cinq (345) Parts Sociales de Catégorie A1, (ii) trois cent quarante-cinq (345) Parts Sociales de
Catégorie A2, (iii) trois cent quarante-cinq (345) Parts Sociales de Catégorie A3, (iv) trois cent quarante-cinq (345) Parts
Sociales de Catégorie A4, (v) sept cent dix-neuf (719) Parts Sociales de Catégorie B1, (vi) sept cent dix-neuf (719) Parts
Sociales de Catégorie B2, (vii) sept cent dix-neuf (719) Parts Sociales de Catégorie B3 et (viii) sept cent dix-neuf (719)
Parts Sociales de Catégorie B4 ont été entièrement souscrites par Coonan Family Superannuation Fund, susmentionné,
ici représenté par Ikrame Dabaj, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée par
acte sous-seing privé, pour un prix de quatre mille deux cent cinquante-six euros (EUR 4.256) et ont été intégralement
libérées par un apport en nature consistant en quatre mille deux cent cinquante-six (4.256) obligations émises par Fairfield
2 d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, détenues à l'encontre de la Société.
La preuve de l'existence et de la valeur de cet apport a été produite au notaire soussigné.
96266
L
U X E M B O U R G
L'apport global d'un montant de quatre mille deux cent cinquante-six euros (EUR 4.256) consiste en deux cent douze
euros et quatre-vingts cents (EUR 212,80) pour le capital social et quatre mille quarante-trois euros et vingt cents (EUR
4.043,20) pour la prime d'émission.
(i) trois cent quarante (340) Parts Sociales de Catégorie A1, (ii) trois cent quarante (340) Parts Sociales de Catégorie
A2, (iii) trois cent quarante (340) Parts Sociales de Catégorie A3, (iv) trois cent quarante (340) Parts Sociales de Catégorie
A4, (v) mille trois cent dix-huit (1.318) Parts Sociales de Catégorie B1, (vi) mille trois cent dix-huit (1.318) Parts Sociales
de Catégorie B2, (vii) mille trois cent dix-huit (1.318) Parts Sociales de Catégorie B3 et (viii) mille trois cent dix-huit
(1.318) Parts Sociales de Catégorie B4 ont été entièrement souscrites par Paul4Viv Pty Limited, susmentionné, ici re-
présenté par Ikrame Dabaj, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée par acte
sous-seing privé, pour un prix de six mille six cent trente-deux euros (EUR 6.632) et ont été intégralement libérées par
un apport en nature consistant en six mille six cent trente-deux (6.632) obligations émises par Fairfield 2 d'une valeur
nominale d'un euro (EUR 1) chacune, détenues à l'encontre de la Société.
La preuve de l'existence et de la valeur de cet apport a été produite au notaire soussigné.
L'apport global d'un montant de six mille six cent trente-deux euros (EUR 6.632) consiste en trois cent trente-et-un
euros et soixante cents (EUR 331,60) pour le capital social et six mille trois cent euros et quarante cents (EUR 6.300,40)
pour la prime d'émission.
(i) deux cent seize (216) Parts Sociales de Catégorie A1, (ii) deux cent seize (216) Parts Sociales de Catégorie A2, (iii)
deux cent seize (216) Parts Sociales de Catégorie A3, (iv) deux cent seize (216) Parts Sociales de Catégorie A4, (v) mille
trois cent dix-huit (1.318) Parts Sociales de Catégorie B1, (vi) mille trois cent dix-huit (1.318) Parts Sociales de Catégorie
B2, (viii) mille trois cent dix-huit (1.318) Parts Sociales de Catégorie B3 et (vii) mille trois cent dix-huit (1.318) Parts
Sociales de Catégorie B4 ont été entièrement souscrites par Gary Fairless Power, susmentionné, ici représenté par Ikrame
Dabaj, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée par acte sous-seing privé, pour
un prix de six mille cent trente-six euros (EUR 6.136) et ont été intégralement libérées par un apport en nature consistant
en six mille cent trente-six (6.136) obligations émises par Fairfield 2 d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune,
détenues à l'encontre de la Société.
La preuve de l'existence et de la valeur de cet apport a été produite au notaire soussigné.
L'apport global d'un montant de six mille cent trente-six euros (EUR 6.136) consiste en trois cent six euros et quatre-
vingt cents (EUR 306,80) pour le capital social et cinq mille huit cent vingt-neuf euros et vingt cents (EUR 5.829,20) pour
la prime d'émission.
(i) cent quarante-et-une (141) Parts Sociales de Catégorie A1, (ii) cent quarante-et-une (141) Parts Sociales de Caté-
gorie A2, (iii) cent quarante-et-une (141) Parts Sociales de Catégorie A3, (iv) cent quarante-et-une (141) Parts Sociales
de Catégorie A4, (v) trois cent cinquante-neuf (359) Parts Sociales de Catégorie B1, (vi) trois cent cinquante-neuf (359)
Parts Sociales de Catégorie B2, (vii) trois cent cinquante-neuf (359) Parts Sociales de Catégorie B3 et (viii) trois cent
cinquante-neuf (359) Parts Sociales de Catégorie B4 ont été entièrement souscrites par M. Jaime Pacreu Vizcaya, sus-
mentionné, ici représenté par Ikrame Dabaj, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration
donnée par acte sous-seing privé, pour un prix de deux mille euros (EUR 2.000) et ont été intégralement libérées par un
apport en nature consistant en deux mille (2.000) obligations émises par Fairfield 2 d'une valeur nominale d'un euro (EUR
1) chacune, détenues à l'encontre de la Société.
La preuve de l'existence et de la valeur de cet apport a été produite au notaire soussigné.
L'apport global d'un montant de deux mille euros (EUR 2.000) consiste en cent euros (EUR 100) pour le capital social
et mille neuf cents euros (EUR 1.900) pour la prime d'émission.
(i) mille huit cent vingt-et-un (1.821) Parts Sociales de Catégorie A1, (ii) mille huit cent vingt-et-un (1.821) Parts Sociales
de Catégorie A2, (iii) mille huit cent vingt-et-un (1.821) Parts Sociales de Catégorie A3, (iv) mille huit cent vingt-et-un
(1.821) Parts Sociales de Catégorie A4, (v) trois mille quatre cent vingt-trois (3.423) Parts Sociales de Catégorie B1, (vi)
trois mille quatre cent vingt-trois (3.423) Parts Sociales de Catégorie B2, (vii) trois mille quatre cent vingt-trois (3.423)
Parts Sociales de Catégorie B3, (viii) trois mille quatre cent vingt-trois (3.423) Parts Sociales de Catégorie B4 et cinquante-
neuf mille (59.000) Parts Sociales de Catégorie C ont été entièrement souscrites par M. Malcolm Fallen, susmentionné,
ici représenté par Ikrame Dabaj, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée par
acte sous-seing privé, pour un prix de vingt-trois mille neuf cent vingt-six euros (EUR 23.926) et ont été intégralement
libérées par un apport en nature consistant en vingt-trois mille neuf cent vingt-six (23.926) obligations émises par Fairfield
2 d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, détenues à l'encontre de la Société.
La preuve de l'existence et de la valeur de cet apport a été produite au notaire soussigné.
L'apport global d'un montant de vingt-trois mille neuf cent vingt-six euros (EUR 23.926) consiste en trois mille neuf
cent quatre-vingt-dix-huit euros et quatre-vingt cents (EUR 3.998,80) pour le capital social et dix-neuf mille neuf cent
vingt-sept euros et vingt cents (EUR 19.927,20) pour la prime d'émission.
(i) cent sept (107) Parts Sociales de Catégorie A1, (ii) cent sept (107) Parts Sociales de Catégorie A2, (iii) cent sept
(107) Parts Sociales de Catégorie A3, (iv) cent sept (107) Parts Sociales de Catégorie A4, (v) sept cent dix-neuf (719)
Parts Sociales de Catégorie B1, (vi) sept cent dix-neuf (719) Parts Sociales de Catégorie B2, (vii) sept cent dix-neuf (719)
Parts Sociales de Catégorie B3 et (viii) sept cent dix-neuf (719) Parts Sociales de Catégorie B4 ont été entièrement
souscrites par Threewise Superannuation Fund, susmentionné, ici représenté par Ikrame Dabaj, résidant professionnel-
96267
L
U X E M B O U R G
lement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée par acte sous-seing privé, pour un prix de trois mille trois cent
quatre euros (EUR 3.304) et ont été intégralement libérées par un apport en nature consistant en trois mille trois cent
quatre (3.304) obligations émises par Fairfield 2 d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, détenues à l'encontre
de la Société.
La preuve de l'existence et de la valeur de cet apport a été produite au notaire soussigné.
L'apport global d'un montant de trois mille trois cent quatre euros (EUR 3.304) consiste en cent soixante-cinq euros
et vingt cents (EUR 165,20) pour le capital social et trois mille cent trente-huit euros et quatre-vingt cents (EUR 3.138,80)
pour la prime d'émission.
- Mr. David George Beeby,
- Mr. John Fell,
- Mr. Wayne Middleton,
- Mr. Joseph James Piccione,
- Mr. Ian Robinson,
- Mr. Andrew Edward Bayliff,
- Mr. George Wilson Allan,
- Mr. Dominic Mark Heaton,
- Dmwake Superannuation Fund,
- I&F Stacey Pty Limited,
- Schooner Superannuation Fund,
- Coonan Family Superannuation Fund,
- Paul4Viv Pty Limited,
- Mr. Gary Fairless Power,
- Mr. Jaime Pacreu Vizcaya,
- Mr. Malcolm Fallen, and
- Threewise Superannuation Fund,
Tous susmentionnés et ici représentés par Ikrame Dabaj, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu de
procurations ci-annexées,
se joignent à l'assemblée générale des associés de la Société et décident ensemble avec l'associé unique sur les points
suivants figurant à l'ordre du jour.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence des résolutions qui précèdent, l'assemblée générale des associés décide de modifier l'article 5.1 des
statuts de la Société qui sera désormais rédigé comme suit:
«Le capital social de la Société est fixé à soixante-dix-huit mille sept cent cinquante-deux euros et soixante cents (EUR
78.752,60) représenté par les parts sociales suivantes:
(i) deux cent quatre-vingt-sept mille cinq cent un (287,501) parts sociales de catégorie A1 d'une valeur nominale d'cinq
cents (EUR 0,05) chacune (les «Parts Sociales de Catégorie A1»);
(ii) deux cent quatre-vingt-sept mille cinq cent un (287,501) parts sociales de catégorie A2 d'une valeur nominale d'cinq
cents (EUR 0,05) chacune (les «Parts Sociales de Catégorie A2»);
(iii) deux cent quatre-vingt-sept mille cinq cent un (287,501) parts sociales de catégorie A3 d'une valeur nominale
d'cinq cents (EUR 0,05) chacune (les «Parts Sociales de Catégorie A3»);
(iv) deux cent quatre-vingt-sept mille cinq cent un (287,501) parts sociales de catégorie A4 d'une valeur nominale
d'cinq cents (EUR 0,05) chacune (les «Parts Sociales de Catégorie A4» et ensemble avec les Parts Sociales de Catégorie
A1, les Parts Sociales de Catégorie A2 et les Parts Sociales de Catégorie A3 les «Parts Sociales de Catégorie A» et leurs
détenteurs collectivement les «Associés de Catégorie A»);
(v) cinquante-quatre mille sept cent soixante-deux (54.762) parts sociales de catégorie B1 d'une valeur nominale d'cinq
cents (EUR 0,05) chacune (les «Parts Sociales de Catégorie B1»);
(vi) cinquante-quatre mille sept cent soixante-deux (54.762) parts sociales de catégorie B2 d'une valeur nominale d'cinq
cents (EUR 0,05) chacune (les «Parts Sociales de Catégorie B2»);
(vii) cinquante-quatre mille sept cent soixante-deux (54.762) parts sociales de catégorie B3 d'une valeur nominale
d'cinq cents (EUR 0,05) chacune (les «Parts Sociales de Catégorie B3»);
(viii) cinquante-quatre mille sept cent soixante-deux (54.762) parts sociales de catégorie B4 d'une valeur nominale
d'cinq cents (EUR 0,05) chacune (les «Parts Sociales de Catégorie B4» et ensemble avec les Parts Sociales de Catégorie
B1, les Parts Sociales de Catégorie B2 et les Parts Sociales de Catégorie B3 les «Parts Sociales de Catégorie B» et leurs
détenteurs collectivement les «Associés de Catégorie B»); et
(ix) deux cent six mille (206.000) parts sociales de catégorie C d'une valeur nominale d'cinq cents (EUR 0,05) chacune
(les «Parts Sociales de Catégorie C» et leurs détenteurs collectivement les «Associés de Catégorie C»).»
96268
L
U X E M B O U R G
<i>Dépensesi>
Le montant des frais, dépenses, honoraires ou charges de toute nature qui incombe à la Société ou qui est mis à sa
charge en raison de cet acte est évalué à environ EUR 2.800,-
Dont acte, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande des parties comparantes, le présent acte
est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français; à la demande desdites parties comparantes et en cas de
divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
L'acte ayant été lu à la mandataire des parties comparantes connues du notaire instrumentant par nom, prénom et
résidence, ladite mandataire des parties comparantes a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: I. DABAJ et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 7 mai 2014. Relation: LAC/2014/21157. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR)
<i>Le Receveuri>
(signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 16 juillet 2014.
Référence de publication: 2014102118/774.
(140123490) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juillet 2014.
Retkauf I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1229 Luxembourg, 15, rue Bender.
R.C.S. Luxembourg B 123.262.
In the year two thousand and fourteen, on the twentieth day of June.
Before us, Maitre Jean SECKLER, notary, residing in Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).
THERE APPEARED:
1. Investec GLL SGO REF Holding Alpha S.à r.l., a private limited liability company incorporated and organised under
the laws of the Grand Duchy of Luxembourg with registered office 15, rue Bender, L-1229 Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg, currently holding two hundred eighteen (218) shares of the Company,
here duly represented by Henri DA CRUZ, employee, with professional address in Junglinster, by virtue of a proxy
given on 18 June 2014, and
2. GLL Management Company S.à r.l., a private limited liability company incorporated and organised under the laws
of the Grand Duchy of Luxembourg with registered office 15, rue Bender, L-1229 Luxembourg, Grand Duchy of Lu-
xembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 116.672, acting in
its own name and on behalf of GLL Retail Center I, FCP-FIS, a fonds commun de placement fonds d'investissement
spécialisé, which is established and exists under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered on the official
list of special investment funds governed by Luxembourg law of 13 February 2007 on specialised investment funds, as
amended, and currently holding two hundred eighty-two (282) shares of the Company,
here duly represented by Henri DA CRUZ, employee, with professional address in Junglinster, by virtue of a proxy
given on 18 June 2014.
The said proxies, signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned notary, will
remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing parties being the shareholders ("Shareholders") of the company "Retkauf I S.à r.l.", a société a respon-
sabilité limitée, having its registered office at 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, registered with the Register of
Commerce and Companies ("RCS") under number B 123262 incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger
on 19 December 2006, published in the Memorial C, Recueil des Societes et Associations number 319, page 15296 on 7
March 2007 (the "Company"). The Articles of the Company were amended for the last time on 14 February 2013 pursuant
to a deed of the notary Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg, published
in the Mémorial C number 873, page 41866, on 12 April 2013.
The appearing parties, representing the whole corporate capital take the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Shareholders hereby resolve to transfer the registered office of the Company from its current address at 6A,route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, to 15, rue Bender, L-1229 Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg at 15, rue Bender, L-1229 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
<i>Second resolutioni>
The Shareholders resolve to amend and fully restate the articles of incorporation of the Company, which will hence-
forth read as follows:
96269
L
U X E M B O U R G
Chapter I. - Form, Name, Registered office, Object, Duration
1. Form - Corporate name. The Company exists as a private limited liability company under Luxembourg law under
the name "Retkauf I S.à r.l." (hereafter referred to as the "Company"), governed by the laws pertaining to such an entity,
and in particular by the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended from time to time (hereafter referred
to as the "Law"), as well as by the present articles of incorporation (hereafter referred to as the "Articles").
2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg.
2.2 It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an
extraordinary general meeting of its Shareholders (as defined hereafter) deliberating in the manner provided for amend-
ments to the Articles.
2.3 However, the Sole Manager (as defined hereafter) or, in case of plurality of managers, the Board of Managers (as
defined hereafter) of the Company is authorised to transfer the registered office of the Company within the City of
Luxembourg.
2.4 Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would
prevent the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be tem-
porarily transferred abroad until such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will however
not have any effect on the nationality of the Company. The decision as to the transfer abroad of the registered office will
be made by the Sole Manager (as defined hereafter) or, in case of plurality of managers, the Board of Managers (as defined
hereafter).
3. Object.
3.1 The purpose of the Company is to (directly or indirectly) acquire, finance, hold and exchange or sell securities of
other entities (having legal personality or not) holding properties either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad
by way of, among others, the subscription or the acquisition of any securities and rights through participation, contribution,
underwriting, firm purchase or option, negotiation or in any other way, and to administrate, develop and manage such
holding of interests.
3.2 The Company may provide financial debt instruments in any form whatsoever to the entities in which it holds a
direct or indirect interest or which form part of the same group of companies as the Company, such as the loans and
guarantees of securities in any kind or form. The Company may borrow in any kind or form and privately issue bonds,
notes or similar debt instruments.
3.3 The Company may further use its funds for the acquisition, development, sale, management and/or lease of real
estate either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as for any other operations relating to real estate.
3.4 The Company may also carry out any commercial, industrial, financial, movable and immovable operations, which
are in direct or indirect relation with its object or which may deem useful in the accomplishment and development of its
purposes.
4. Duration. The Company is incorporated for an unlimited period.
Chapter II. - Capital, Shares
5. Share capital.
5.1 The corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by twelve thousand
five hundred (12,500) shares with a nominal value one euro (EUR 1) each (hereafter referred to as a "Share" and collec-
tively as the "Shares"). The holders of the Shares are together referred to as the "Shareholders" or solely the
"Shareholder".
5.2 In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account (the "Premium Account"), into which
any premium paid on any Share or any other contribution made without the issuance of Shares is transferred. The amount
of said Share Premium Account is at the free disposal of the Shareholder(s). The amount of the premium account may
be used to make payment for any Shares, which the Company may redeem from its Shareholder(s), to offset any net
realized losses, to make distributions to the Shareholder(s) or to allocate funds to the legal reserve.
5.3 All Shares will have equal rights.
5.4 The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the limits set by the Law.
6. Shares indivisibility. Towards the Company, the Shares are indivisible, so that only one owner is admitted per Share.
Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
7. Transfer of shares.
7.1 A transfer of Shares shall generally only be allowed to a corporate body.
7.2 Pre-emption Right
(a) Within 18 months as from 20 June 2014, the Shares may be transferred only to a Qualified Transferee (as defined
below) and each Shareholder shall have a pre-emption right for the Shares of the other Shareholder.
96270
L
U X E M B O U R G
(b) Qualified Transferee means an institutional investor having sufficient financial resources to cover all obligations
arising from its position as a Shareholder ("Qualified Transferee"). The financial status of the Qualified Transferee shall
be proven by its annual financial statements and turnover for the last three business years and / or appropriate financial
guarantee.
(c) If a Shareholder intends to make a binding offer to sell its Shares to a Qualified Transferee ("Initiating Shareholder"),
or receives a binding offer to purchase its Shares from a Qualified Transferee and such Initiating Shareholder decides to
sell such Shares, the Initiating Shareholder shall first make a written offer ("Offer") to sell such Shares to the other
Shareholder ("Offeree") on the same terms and conditions as the Initiating Shareholder intends to sell to the Qualified
Transferee. The Offer shall contain all specific and detailed information relating to the proposed sale by the Initiating
Shareholder to the Qualified Transferee.
(d) If the Offeree intends to accept the Offer, it shall give written notice to the Initiating Shareholder within forty-five
(45) days upon the receipt of the Offer. The sale and purchase agreement between the Initiating Shareholder and the
Offeree for all, but not less than all, of the Shares which are the subject of the Offer shall come into existence upon
receipt by the Initiating Shareholder of the written notice of the Offeree accepting the Offer.
(e) If the Offeree does not give written notice of its intention to purchase the Shares pursuant to the Offer within
forty-five (45) days of receipt by the Offeree of the Offer, the Offeree shall be deemed to have refused the Offer and
have not exercised its pre-emption right.
(f) After the expiry of the forty-five (45) days period set out in clause 7.2.(d) without the Offeree expressing its intention
to purchase the Shares, the Initiating Shareholder shall have the right to sell not less than all of the Shares specified in the
Offer to the Qualified Transferee on terms and conditions no more favourable to the Qualified Transferee than the terms
and conditions set forth in the Offer.
(g) The Offeree may appoint a member of its Group (the "Group") to exercise the pre-emption right. For the sake of
clarity, Group shall include for the purpose of this clause any subsidiary of the unitholders / shareholders of the Share-
holders.
7.3 Right of First Offer
(a) Upon expiry of the 18 months period as from 20 June 2014, each Shareholder shall have a right of first offer for
the Shares of the other Shareholder in accordance with this clause 7.3.
(b) If the Initiating Shareholder intends to make a non-binding offer to sell its Shares to a third party potential purchaser
("Potential Purchaser"), or receives a non-binding offer to purchase its Shares from a Potential Purchaser and such Initiating
Shareholder decides to sell such Shares, the Initiating Shareholder shall first make an Offer to sell such Shares to the
Offeree on the same terms and conditions as the Initiating Shareholder intends to sell to the Potential Purchaser. The
Offer shall only contain the total amount of the Shares to be sold and the sale price relating to the prosposed sale by the
Initiating Shareholder to the Potential Purchaser.
(c) If the Offeree intends to accept the Offer, it shall give written notice to the Initiating Shareholder within forty-five
(45) days upon the receipt of the Offer. The sale and purchase agreement between the Initiating Shareholder and the
Offeree for all, but not less than all, of the Shares which are the subject of the Offer shall come into existence upon
receipt by the Initiating Shareholder of the written notice of the Offeree accepting the Offer.
(d) If the Offeree does not give written notice of its intention to purchase the Shares pursuant to the Offer within
forty-five (45) days of receipt by the Offeree of the Offer, the Offeree shall be deemed to have refused the Offer and
have not exercised its right of first offer.
(e) After expiry of the forty-five (45) days period set out in clause 7.3 (d) without the Offeree expressing its intention
to purchase the Shares, the Initiating Shareholder shall, for a period of six (6) months from the date of the receipt of the
Offer by the Offeree, have the right to sell not less than all of the Shares specified in the Offer to the Potential Purchaser
or any third party at a price which is at least 95% of the price mentioned in the Offer and on terms and conditions no
more favourable to the Potential Purchaser (or any third party) than the terms and conditions set forth in the Offer.
(f) The Offeree may appoint a member of its Group to exercise the right of first offer. For the sake of clarity, Group
shall include for the purpose of this clause any subsidiary of the unitholders / shareholders of the Shareholders.
7.4 Intra-Group Transfer
(a) Shareholders may freely transfer their Shares to a member of their Group. For the sake of clarity, Group shall
include for the purpose of this clause any subsidiary of the unitholders / shareholders of the Shareholders.
(b) In the event of a transfer by a Shareholder of its Shares to a member of the Group of such Shareholder ("New
Shareholder") the transferring Shareholder ("Transferor") shall undertake direct surety to the other Shareholder for the
obligations of such New Shareholder under this Agreement.
(c) The Transferor and the New Shareholder shall notify the other Shareholder of the New Shareholder ceasing to
be a member of the Transferor's Group und the transferor shall reacquire such Shares from the New Shareholder (or
such Shares shall be retransferred to the Transferor, as the case may be, immediately prior to the New Shareholder
ceasing to be a member of the Transferor's Group). Transfer agreements in respect of a transfer of Shares to a member
of the Shareholder's Group shall include effective and enforceable provisions requiring the transferor to reacquire such
Shares from the New Shareholder and the obligation of the New Shareholder to resell and retransfer such shares to the
96271
L
U X E M B O U R G
Transferor if the New Shareholder ceases to be a member of the Transferor's Group. No transfer of Shares to a member
of the transferor's Group may take effect unless and until the Transferor evidences to the other Shareholder that it has
fully complied with the obligations set out in this clause
7.4. Each Shareholder shall provide to the other Shareholder such information as the other may reasonably need to
ascertain that the New Shareholder has not ceased to be a member of the Transferor's Group.
Chapter III. - Management
8. Management.
8.1 The Company is managed by one manager (the "Sole Manager") or several managers. If several managers have been
appointed, they will constitute a board of managers (the "Board of Managers", each member individually, a "Manager").
The Sole Manager or the members of the Board of Managers, as the case may be, need not be shareholder.
8.2 The Sole Manager or the members of the Board of Managers may be removed at any time by decision of the
extraordinary general meeting of the Shareholders taken in compliance with Chapter IV.
8.3 Any decision in connection with the management of the Company shall be taken by the Sole Manager or, in case
of plurality of managers, collectively by the Board of Managers in compliance with Article 12.
8.4 Towards third parties, the general power of representation of the Company is granted to the Sole Manager and
in case of plurality of managers, to any two Managers as provided by Article 10 of the Articles, and pursuant to Article
191 bis paragraph 5 of the Law, any deed, agreement or generally any document executed in compliance with Articles 8
and 10 of the present Articles are valid and binding vis-à-vis third parties. The exercise of the general power of repre-
sentation by any two Managers does not require prior approval by the Board of Managers acting collectively.
8.5 The Managers may not, by reason of their mandate, be held personally held liable for any commitments validly
made by them in the name of the Company, provided such commitments comply with the Articles and the Law.
Without prejudice to the preceding paragraph, the limitation period for any action that may be brought by the Company
against any Manager shall be one year, unless a decision has been taken by Shareholders to discharge the Sole Manager
or, in case of plurality of managers, the Management Board from liabilities in accordance with Article 13.9 before expiry
of such one year limitation period, in which case the enforceability of claims against the Managers ceases upon the
Shareholders granting such discharge.
8.6 The Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers shall be assisted by a joint Advisory
Board.
The Advisory Board will comprise up to 10 members formally appointed the Sole Manager or, in case of plurality of
managers, the Board of Managers (the "Advisory Board Members" or solely the "Advisory Board Member").
Advisory Board Members shall be determined by way of a look-through procedure determing the indirect participation
of the ultimate investors of the Shareholders ("Ultimate Investors") ("Indirect Participation"). For the purpose of the
determination of the Indirect Participation, the Shareholders are therefore deemed transparent with regard to the right
of representation in the Advisory Board.
The Indirect Participation shall be determined according to the following formula:
IP= S x I
Whereas:
IP= Indirect Participation
S= % of shareholding of respective Shareholder in the Company
I= % of investment of Ultimate Investor in the respective Shareholder
Ultimate Investors whose Indirect Participation exceed 10.00 % are entitled to dispatch a representative to the Ad-
visory Board. For the avoidance of doubt, no Ultimate Investor may appoint more than one Advisory Board Member,
regardless of the size of its Indirect Participation. The voting rights of the Advisory Board Members are equal to the
Indirect Participation of the Ultimate Investor.
There will be no quorum for the meetings of the Advisory Board, however major decisions as mentioned under a-f
of this clause 8.6 require the approval of 60% of the existing voting rights of the Advisory Board. If the required majority
of 60% of the existing voting rights is not achieved, a second meeting shall be convoked within 20 business days in order
to re-discuss the issue presented based on further information and documentation to be provided.
If the required majority of 60% of the existing voting rights of the Advisory Board is not achieved in the second meeting,
the procedure as described under 8.7 will apply.
The Advisory Board will generally meet in Luxembourg. The Advisory Board shall meet upon a call from the Sole
Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers, the chairman of the Advisory Board or by any
Advisory Board member and shall meet at least every year.
The Advisory Board members shall vote in writing or meet by phone or in-person following upon not less than five
(5) Bank Business Days’ notice (unless waived by each Advisory Board member in writing) of the matters to be considered
and discussed by the Advisory Board.
96272
L
U X E M B O U R G
Unless the Advisory Board votes in writing, the minutes of the Advisory Board meeting shall be signed by the chairman
of the Advisory Board.
Advisory Board members may appoint proxies to attend meetings to the extent permissible under applicable law.
The Advisory Board shall give its prior approval to the Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of
Managers before the Board of Managers decide about one of the following points for the Company:
a) Potential new investments other than the investments in the Company
b) Disposal of investments
c) any conflict of interests referred to it by the Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers
d) any specific matters which, upon decision of the General Meeting of Shareholders, must be submitted for the
approval of the Advisory Board.
e) Mortgaging or encumbering the Properties or a Property held by the Company other than the initial mortgaging or
encumbering performed in relation to the acquisition of the Company by the Shareholders or any such mortgaging or
encumbering that may be required for the acquisition of the Company by the Shareholders;
f) Any financing or refinancing in excess of the financing by the Shareholders in relation with the acquisition of the
Company by the Shareholders and back-to-back financing via shareholder loans granted by the Shareholders (including
Investec GLL Special Opportunities Real Estate Fund, FCP-FIS) to the Company.
8.7 A Drag Along Event shall be deemed to have occurred in respect of those matters as mentioned under clause 8.6.
b) above requiring the Advisory Board’s approval if:
i. disposal of investments is required due to the expiration of the lifetime of GLL Retail Center I, FCP-FIS or Investec
GLL Global Special Opportunities Real Estate Fund (the "Funds"), and
ii. the Fund(s) has / have not shortened their lifetimes, or
iii. The second meeting of the Advisory Board failed to achieve the required 60% majority of the existing voting rights
of the Advisory Board to agree on the disposal of the respective investments.
(a) A Drag Along Event as defined above under i.-iii. shall not occur before 29 May 2017. The Shareholders be obliged
to meet at least once within the month following the second meeting to negotiate the Drag Along Event. If the Drag
Along Event cannot be resolved by the Advisory Board within one month after the second meeting as described under
8.6 (which, for the avoidance of doubt in the case of an Advisory Board's refusal to consent shall be the date of the
Advisory Board meeting or the date of the circular resolution of the Advisory Board not achieving the majority requi-
rement as set out under 8.6 (should the circular resolution consist of several separate documents, the date of the last
received resolution shall be decisive), the Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers shall
determine the value of the Shares in the Company. For this purpose the Sole Manager or, in case of plurality of managers,
the Board of Managers shall procure a current value of the investment properties ("Current Value") of the Company.
The Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers shall propose a list of at least three know-
ledgeable, independent and reputable third party appraisers (together the "Independent Appraisers" or solely the
"Independent Appraiser") to the Advisory Board. In case the Advisory Board appoints a single Independent Appraiser
with 60% majority of the existing voting rights this Independent Appraiser shall be engaged by the Sole Manager or, in
case of plurality of managers, the Board of Managers to determine the "Current Value" and the (Final) Drag Along Price.
In case the Advisory Board does not appoint a single Independent Appraiser, the Sole Manager or, in case of plurality of
managers, the Board of Managers shall engage three Independent Appraisers to value the assets with the average of all
three valuations used to determine the Current Value and to establish the Drag Along Prices.
(b) The valuation of the Shares shall be carried out according to the following formula and shall determine the Drag
Along Price of the Shares in the Company to be established by each Independent Appraiser (the "Drag Along Prices"):
- the last IFRS equity adjusted for the cash flow from operations, but without gains/losses from property dispositions
and non-amortized acquisition costs..
- less the book value of the investment properties
- plus the Current Value
- less distributions from realized dispositions
- less disposition and liquidation costs of the Company
(c) After determination of the Drag Along Prices and if three Independent Appraisers have been engaged, the Drag
Along Prices established by the Independent Appraisers shall be compared by the Sole Manager or, in case of plurality of
managers, the Board of Managers and if the deviation, if any, of the Drag Along Prices established by the Independent
Appraisers does not exceed 10.00%, the Final Drag Along Price shall be the average of all three Drag Along Prices as
established by the Independent Appraisers.
(d) In case the deviation between the Drag Along Prices established by the Independent Appraisers exceeds 10.00%,
the Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers shall appoint a fourth Independent Appraiser
(the "Fourth Independent Appraiser") who will perform an assessment on which Drag Along Prices established by the
Independent Appraisers rather mirrors his valuation assessment. According to the assessment of the Fourth Independent
Appraiser such Drag Along Price shall be the Final Drag Along Price.
96273
L
U X E M B O U R G
(e) The Shareholder for whom the Drag Along Event is confirmed according to a. above (the "First Shareholder") may
serve a notice ("Offer Notice") in writing on the other Shareholder (the "Second Shareholder") offering to transfer to
the Second Shareholder the Shares in the Company for the time being held by the First Shareholder (the "First Sale
Shares") for the Final Drag Along Price. The Second Shareholder may accept the Offer Notice itself or may appoint a
member of its Group to purchase the First Sale Shares. For the sake of clarity, Group shall include for the purpose of
this clause any subsidiary of the unitholders / shareholders of the Shareholders.
(f) The First Shareholder shall serve a copy of the Offer Notice on the Company at the same time as the Offer Notice
is served on the Second Shareholder.
(g) The Second Shareholder or the respective appointed Group member shall notify the First Shareholder in writing
within 20 Business Days from the date of receipt of the Offer Notice whether or not it is willing to purchase the First
Sale Shares on the terms and conditions set out in the Offer Notice.
(h) If the Second Shareholder or the respective appointed Group member gives notice in writing to the First Share-
holder that it is willing to purchase the First Sale Shares on the terms and conditions set out in the Offer Notice, the
First Shareholder shall be obliged to transfer the First Sale Shares to the Second Shareholder or the respective appointed
Group member at the Final Drag Along Price. The Second Shareholder or the respective appointed Group member shall
within 20 Business Days after giving notice in writing to the First Shareholder, pay to the First Shareholder the price set
out in the Offer Notice for the First Sale Shares and the First Shareholder shall deliver within 15 Business Days upon
receipt of the Final Drag Along Price to the Second Shareholder or the respective appointed Group member duly executed
transfers in favour of the Second Shareholder and the share certificate(s) representing the First Sale Shares. The Final
Drag Along Price shall be subject to a post closing price adjustment based on audited closing IFRS financial statements.
(i) If the Second Shareholder gives notice in writing to the First Shareholder that it is not willing to purchase the First
Sale Shares on the terms and conditions set out in the Offer Notice ("Negative Notice"), the Exit Procedure according
to the Joint Venture Agreement entered into between the Shareholders and Investec GLL Fund Management Company
S.A. acting in its own name but on behalf of Investec GLL Global Special Opportunities Real Estate Fund ("Joint Venture
Agreement") shall be started.
(j) If, after the expiry of the 20 Business Day period referred to above, the Second Shareholder has not given any notice
in writing to the First Shareholder in accordance with sub clause h. above, the Second Shareholder shall be deemed to
have refused the offer made by the First Shareholder and thus the Exit Procedure in accordance with the Joint Venture
Agreement shall be started.
9. Powers of the sole manager or of the board of managers.
9.1 In dealing with third parties, the Sole Manager and in case of plurality of managers, the Board of Managers, without
prejudice to Articles 8 and 10 of the present Articles, will have all powers to act in the name of the Company in all
circumstances and to carry out and approve all transactions and other operations consistent with the Company’s objects.
9.2 All powers not expressly reserved by law or by the Articles to the general meeting of Shareholders fall within the
competence of the Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers.
10. Representation of the company. Towards third parties, the Company will be bound in all circumstances (i) by the
individual signature of the Sole Manager; (ii) in case more than one Manager has been appointed, by the joint signatures
of any two Managers; or (iii), as the case may be, by the joint or single signature(s) of any person(s) to whom such signatory
power has been validly delegated in accordance with the Articles.
11. Delegation and agent of the sole manager or of the board of managers.
11.1 The Sole Manager or any two Managers in case of plurality of managers may delegate powers for specific tasks
to one or more ad hoc agents.
11.2 The Sole Manager or any two Managers in case of plurality of managers will determine any such agent’s respon-
sibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of its
agency.
12. Meeting of the board of managers.
12.1 In case of a Board of Managers, the meetings of the Board of Managers are convened by any Manager and at the
place indicated in the convening notice. Written notice (including via e-mail) of any meeting of the Board is given to all
Managers at least forty-eight (48) hours in advance, except in case of emergency, the nature and circumstances of which
are set forth in the notice of the meeting.
12.2 No notice is required if all the members of the Board are present or represented and if they state to have full
knowledge of the agenda of the meeting. Notice of a meeting may also be waived in writing (including via e-mail or similar
electronic transmission) by a Manager, either before or after a meeting. Separate written notices are not required for
meetings that are held at times and places indicated in a schedule previously adopted by the Board, or determined in a
prior meeting as documented in the related Board minutes.
12.3 Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by telegram, fax, e-mail
or letter another Manager as his proxy. A Manager may also appoint by phone another Manager to represent him, which
shall be confirmed in writing at a later stage.
96274
L
U X E M B O U R G
12.4 The Board of Managers shall choose from amongst its members a chairman (the "Chairman"). The Chairman shall
preside at all meetings of the Board. In his absence or incapacity to act, the Managers present may appoint anyone of
them to act as chairman for the purpose of the meeting (chairman pro tempore).
12.5 The Board of Managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.
The resolutions by the Board of Managers are validly adopted if approved by the majority of its members.
12.6 The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating
Manager is able to hear and to be heard by all other participating members of the Board of Managers whether or not
using this technology, and each so participating Manager shall be deemed to be present and shall be authorised to vote
by video or by telephone.
12.7 Written resolutions of the Board of Managers can be validly taken if approved in writing and signed by all the
members of the Board of Managers. Such approval may be in a single or in several separate documents sent by fax, e-
mail, or by similar means. These resolutions shall have the same effect as resolutions voted at the Board of Managers'
meetings, physically held. Written resolutions become valid on the date of the last signature by a Manager or, in case of
partially or fully undated signatures, on the date of receipt of the last signed resolutions at the registered office of the
Company.
12.8 Votes may also be cast by fax, e-mail, phone or similar means provided in such latter event such vote is confirmed
in writing. The minutes signed in accordance with the Articles and documenting the subject vote are considered to be
such confirmation in writing.
12.9 The minutes of a meeting of the Board of Managers shall be signed by the Chairman or, in his absence, the chairman
pro tempore of the meeting, or at least two members of the Board of Managers present or represented at the meeting.
Extracts shall be certified by any Manager or by any person nominated by any Manager or during a meeting of the Board
of Managers.
12.10 In case of a Sole Manager, the resolutions of the Sole Manager may be documented in writing.
Chapter IV. - General meeting of shareholders
13. Powers of the general meeting of shareholder(s), Constitution and holding of meetings, - Votes.
13.1 Resolutions of the Shareholders are adopted at a general meeting of Shareholders (the "General Meeting") or by
way of circular resolutions (the "Shareholders Circular Resolutions").
13.2 Where resolutions are to be adopted by way of Shareholders Circular Resolutions, the text of the resolutions is
sent to all the Shareholders, in accordance with the Articles. Shareholders Circular Resolutions signed by all the Share-
holders are valid and binding as if passed at a General Meeting duly convened and held and bear the date of the last
signature.
13.3 Each share entitles to one (1) vote.
13.4 The Shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing at the initiative of any Manager or
Shareholders representing more than one-half of the share capital.
13.5 Written (including via e-mail) notice of any General Meeting is given to all Shareholders at least five (5) days in
advance of the date of the meeting, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in
the notice of the meeting.
13.6 General Meetings are held at such place and time specified in the notices.
13.7 If all the Shareholders are present or represented and consider themselves as duly convened and informed of the
agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice.
13.8 A Shareholder may grant a written power of attorney to another person, whether or not a Shareholder, in order
to be represented at any General Meeting.
13.9 Whatever the number of Shareholders, the balance sheet and profit and loss account shall be submitted to the
Shareholders for approval who also shall vote specifically as to whether discharge is to be given to the Sole Manager or,
in case of plurality of managers, to the Board of Managers.
14. Sole shareholder.
14.1 Where the number of Shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers conferred
by the Law to the General Meeting.
14.2 Any reference in the Articles to the Shareholders and the General Meeting or to Shareholders Circular Resolu-
tions is to be read as a reference to such sole shareholder or the resolutions of the latter, as appropriate.
14.3 The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.
15. Majorities.
15.1 Collective decisions are only validly taken insofar as Shareholders owning more than half of the share capital adopt
them. If that figure is not reached at the first meeting or first written consultation, the Shareholders may be convened
or consulted a second time, by registered letter, and decisions shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless
of the portion of capital represented.
96275
L
U X E M B O U R G
15.2 Resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority (in number) of the Shareholders owning at
least three-quarters of the Company’s share capital, in accordance with any provisions of the Law.
15.3 However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its Shareholders may be
increased only with the unanimous consent of all the Shareholders and in compliance with any other legal requirement.
Chapter V. - Business year
16. Business year.
16.1 The Company’s financial year starts on the first day of January and ends on the last day of December of each year.
16.2 At the end of each financial year, the Company’s accounts, as well as an inventory indicating the value of the
Company’s assets and liabilities, are established by the Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of
Managers.
16.3 Each Shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
17. Distribution right of shares.
17.1 From the annual net profit of the Company, five per cent shall be deducted and allocated to a legal reserve. That
deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal reserve reaches one tenth of the Company's share
capital.
17.2 The Shareholders determine how the balance of the annual net profits is disposed of. It may allocate such balance
to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward.
17.3 The decision to distribute dividends and the determination of the amount of such a distribution will be taken by
the general meeting of the Shareholders.
17.4 The Board of Managers or the Sole Manager may, within the limits set forth by the Law and the Articles, decide
to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the Board of Managers or the Sole Manager
showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not
exceed realized profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable reserves,
but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these
Articles.
Chapter VI. - Liquidation
18. Causes of dissolution. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights,
insolvency or bankruptcy of the single Shareholder or of one of the Shareholders.
19. Liquidation.
19.1 The liquidation of the Company can only be decided if approved by a majority of the Shareholders representing
at least three-quarters of the Company’s share capital.
19.2 The liquidation will be carried out by one or several liquidators, Shareholders or not, appointed by the Share-
holders who shall determine their powers and remuneration.
19.3 A sole Shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally
the payment of all its assets and liabilities, known or unknown of the Company.
Chapter VII. - Applicable law
20. Applicable law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is
made in these Articles.
21. Severability. Should any of the provisions of these Articles be held to be invalid or unenforceable by a body of
competent jurisdiction, such provision shall be replaced by a provision which construes or limits the provision held to
be invalid or unenforceable to the extent necessary to eliminate such invalidity or unenforceability and which shall be as
close as possible to the original intention of the provision held to be invalid or unenforceable. The other provisions of
these Articles shall remain in full force and effect.
<i>Third resolutioni>
The Shareholders hereby resolve that Deloitte Audit, société à responsabilité limitée, with its registered office located
at 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under
the number B. 67.895 shall be appointed as independent auditors of the Company for the forthcoming fiscal year.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a German version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.
WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, he signed together with the notary the present deed.
96276
L
U X E M B O U R G
Es folgt die deutsche Übersetzung:
Im Jahre zweitausendvierzehn, den zwanzigsten Juni.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, Großherzogtum Luxemburg
ERSCHEINEN
1. Investec GLL SGO REF Holding Alpha S.à r.l., eine nach luxemburgischem Recht gegründete und organisierte Ge-
sellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit Sitz in 15, Rue Bender, L-1229 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg, im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister ("RCS") eingetragen unter der Nummer
B 136.469, zum gegenwärtigen Zeitpunkt Inhaber von zweihundertachtzehn (218) Anteilen an der Gesellschaft;
hier vertreten durch Herrn Henri DA CRUZ, Privatbeamter geschäftsansässig in Junglinster, aufgrund einer Vollmacht
vom 18. Juni 2014, und
2. GLL Management Company S.à r.l., eine nach luxemburgischem Recht gegründete und organisierte Gesellschaft mit
beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit Sitz in 15, Rue Bender, L-1229 Luxemburg, Großherzogtum
Luxemburg, im RCS eingetragen unter der Nummer B 116.672, im eigenen Namen und handelnd für GLL Retail Center
I, FCP-FIS, welcher in der Form eines fonds commun de placement - fonds d'investissement spécialisé gemäß dem Lu-
xemburger Gesetz vom 13. Februar 2007 über Spezialisierte Investmentfonds, in seiner aktuellen Fassung, aufgelegt wurde
und zum gegenwärtigen Zeitpunkt Inhaber von zweihundertzweiundachtzig Anteilen (282) an der Gesellschaft ist;
hier vertreten durch Herrn Henri DA CRUZ, Privatbeamter geschäftsansässig in Junglinster, aufgrund einer Vollmacht
vom 18. Juni 2014.
Die Vollmachten, die vom Bevollmächtigten der Erschienenen sowie dem unterzeichneten Notar mit ne varietur un-
terzeichnet werden, bleiben der vorliegenden Urkunde dauerhaft beigefügt, und werden zusammen und zeitgleich mit
dieser Urkunde bei den jeweiligen Registerstellen eingereicht.
Die Erschienenen sind die Gesellschafter ("Gesellschafter") der Gesellschaft "Retkauf I S.à r.l.", einer Gesellschaft mit
beschränkter Haftung (société a responsabilité limitée), mit Gesellschaftssitz in 6A, route de Trèves, L-2633 Senninger-
berg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im RCS unter Nummer B 123262, gegründet durch eine von Maître Joseph
Elvinger am 19. Dezember 2006 errichtete und 7. März 2007 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
Nummer 319, Seite 15296 veröffentlichte Urkunde ("Gesellschaft"). Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt am 14.
Februar 2013 gemäß einer von Maître Paul Bettingen, Notar mit Amtssitz in Niederanven, Großherzogtum Luxemburg,
errichteten und am 12. April 2013 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 873, Seite 41866
veröffentlichten Urkunde geändert.
Die Erschienenen, die das gesamte Gesellschaftskapital vertreten, fassen hiermit die folgenden Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Gesellschafter beschließen hiermit, den Sitz der Gesellschaft von 6A, Route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Großherzogtum Luxemburg nach 15, rue Bender, L-1229 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg zu verlegen
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Gesellschafter beschliessen, die Satzung der Gesellschaft, die künftig lautet wie folgt, hiermit zu ändern und voll-
ständig zu neu fassen:
Kapitel I. - Rechtsform, Firma, Sitz, Gegenstand und Dauer
1. Rechtsform, Firma der Gesellschaft.
1.1 Die Gesellschaft besteht in der Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (private limited liability
company) nach luxemburgischem Recht mit der Firma "Retkauf I S.à r.l." (nachstehend "Gesellschaft"), für die diejenigen
rechtlichen Bestimmungen gelten, die auf eine solche Gesellschaft Anwendung finden, insbesondere das Gesetz über
Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 in der jeweils geltenden Fassung (nachstehend "Gesetz über Handelsgesell-
schaften") und die vorliegende Satzung (nachstehend "Satzung").
2. Sitz.
2.1 Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt.
2.2 Der Sitz der Gesellschaft kann durch einen Beschluss der außerordentlichen Versammlung der Gesellschafter (wie
nachstehend definiert), der in der für Änderungen der Satzung vorgesehenen Weise gefasst wurde, an einen beliebig
anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.
2.3 Allerdings ist der Alleiniger Geschäftsführer (wie nachstehend definiert), bzw. bei Vorhandensein mehrerer Ge-
schäftsführer, die Geschäftsführung (wie nachstehend definiert) befugt, den Sitz der Gesellschaft innerhalb der Stadt
Luxemburg zu verlegen.
2.4 Sofern eine militärische, politische, wirtschaftliche oder soziale Situation eintritt oder offenbar unmittelbar be-
vorsteht, die die gewöhnliche Geschäftstätigkeit am Sitz der Gesellschaft verhindern würde, kann der Sitz der Gesellschaft
vorübergehend ins Ausland verlegt werden, bis sich die Situation normalisiert hat. Eine solche vorübergehende Maßnahme
hat jedoch keine Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die eine luxemburgische Gesellschaft bleibt. Die
96277
L
U X E M B O U R G
Entscheidung über die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft ins Ausland trifft der Alleinige Geschäftsführer (wie nach-
stehend definiert), bzw. bei Vorhandensein mehrerer Geschäftsführer, die Geschäftsführung (wie nachstehend definiert).
3. Gesellschaftszweck.
3.1 Der Zweck der Gesellschaft besteht darin, Wertpapiere anderer Unternehmen (mit oder ohne eigene Rechts-
persönlichkeit), die über Immobilien in Luxemburg oder im Ausland verfügen, (unmittelbar oder mittelbar) zu erwerben,
zu finanzieren, zu halten und zu tauschen oder zu veräußern, beispielsweise durch Zeichnung oder Erwerb von Wertpa-
pieren und Rechten durch Beteiligung, Einlage, Übernahme einer Emission, Kauf oder Option, Begebung oder in sonstiger
Weise, und entsprechende Portfolios zu verwalten, auszubauen und damit zu wirtschaften.
3.2 Die Gesellschaft kann den Unternehmen, an denen sie unmittelbare oder mittelbare Beteiligungen hält, oder die
Teil derselben Unternehmensgruppe sind wie die Gesellschaft selbst, Schuldinstrumente in beliebiger Form, beispielsweise
Darlehen und Wertpapiergarantien zur Verfügung stellen. Die Gesellschaft kann Anleihen, Schuldverschreibungen oder
vergleichbare Schuldtitel in beliebiger Art oder Weise ausleihen bzw. im Rahmen von Privatplatzierungen ausgeben (issue
privately).
3.3 Die Gesellschaft kann ihre Mittel außerdem zum Erwerb, zur Erweiterung, zur Veräußerung, Bewirtschaftung und/
oder zur Vermietung von Immobilien im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland, sowie für andere Geschäfte mit
Bezug zu Immobilien verwenden.
3.4 Die Gesellschaft kann zudem Geschäfte in den Bereichen Wirtschaft, Industrie, Finanzen, Mobilien und Immobilien
machen, wenn diese in unmittelbaren oder mittelbaren Zusammenhang mit ihrem Gesellschaftszweck stehen, oder ihrer
Einschätzung zur Erreichung oder Förderung ihrer Zwecke sinnvoll sind.
4. Dauer des Bestehens. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet.
Kapitel II. - Kapital, Anteile
5. Stammkapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) und besteht aus zwölftausendfünf-
hundert Anteilen (12.500) mit einem Nennbetrag von jeweils einem Euro (EUR 1) (nachstehend "Anteil" bzw. "Anteile").
Inhaber der Anteile werden jeweils auch als "Gesellschafter" bezeichnet.
5.2 Zusätzlich zum Gesellschaftskapital kann ein Aufgeldkonto (das "Aufgeldkonto") eingerichtet werden, auf das An-
teilsaufgelder oder andere Einlagen überwiesen werden, die geleistet werden, ohne dass eine Ausgabe von Anteilen erfolgt.
Der Betrag auf dem Aufgeldkonto steht dem (oder den) Gesellschafter(n) zur freien Verfügung. Der Betrag auf dem
Aufgeldkonto kann verwendet werden, um Zahlungen auf Anteile zu leisten, die die Gesellschaft gegebenenfalls von ihrem
(oder ihren) Gesellschafter(n) zurücknimmt, um realisierte Nettoverluste auszugleichen, um Ausschüttungen an den (oder
die) Gesellschafter vorzunehmen, oder um ihn in die gesetzlichen Rücklagen einzustellen.
5.3 Alle Anteile sind mit den gleichen Rechten verbunden.
5.4 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Aktien innerhalb der vom Gesetz über Handelsgesellschaften vorgesehenen
Grenzen zurückkaufen.
6. Unteilbarkeit der Anteile. Im Verhältnis zur Gesellschaft sind die Anteile unteilbar, so dass nur ein Inhaber pro Anteil
zugelassen ist. Miteigentümer haben eine einzige Person als Vertreter gegenüber der Gesellschaft zu bestimmen.
7. Übertragung von Anteilen.
7.1 Eine Übertragung von Anteilen ist grundsätzlich nur an eine Gesellschaft zulässig.
7.2 Vorkaufsrecht
(a) Innerhalb von 18 Monaten ab dem 20. Juni 2014 können die Anteile übertragen werden, und zwar nur an einen
Geeigneten Empfänger (wie nachstehend definiert); jeder Gesellschafter hat ein Vorkaufsrecht bezüglich der Anteile des
anderen Gesellschafters.
(b) Ein Geeigneter Empfänger ist ein institutioneller Anleger, der über ausreichende finanzielle Ressourcen verfügt, um
allen Verpflichtungen nachzukommen, die aus seiner Position als Gesellschafter entstehen ("Geeigneter Empfänger"). Der
Nachweis der Finanzlage des Geeigneten Empfängers erfolgt durch dessen Jahresabschlüsse und Umsätze für die drei
letzten Geschäftsjahre und/oder geeignete finanzielle Garantien.
(c) Wenn ein Gesellschafter beabsichtigt, ein verbindliches Angebot über den Verkauf seiner Anteile gegenüber einem
Geeigneten Empfänger abzugeben ("Anbieter"), oder wenn er ein verbindliches Angebot über den Erwerb seiner Anteile
von einem Geeigneten Empfänger erhält, und der Anbieter entscheidet, diese Anteile zu verkaufen, wird er zunächst ein
schriftliches Angebot ("Angebot") über den Verkauf der Anteile an den anderen Gesellschafter ("Angebotsempfänger")
zu denselben Konditionen abgeben, zu denen er beabsichtigt, an den Geeigneten Empfänger zu verkaufen. Das Angebot
enthält alle konkreten und detaillierten Informationen zum geplanten Verkauf seitens des Anbieters an den Geeigneten
Empfänger.
(d) Wenn der Angebotsempfänger beabsichtigt, das Angebot anzunehmen, teilt er dies dem Anbieter innerhalb von
fünfundvierzig (45) Tagen nach dem Zugang des Angebots mit. Der Kaufvertrag zwischen dem Anbieter und dem Ange-
botsempfänger über alle Anteile, auf die sich das Angebot bezieht, kommt zustande, wenn die schriftliche Mitteilung des
96278
L
U X E M B O U R G
Angebotsempfänger über die Annahme des Angebots dem Anbieter zugeht; ein Kaufvertrag über eine geringere Zahl von
Anteilen kann auf diesem Wege nicht abgeschlossen werden.
(e) Wenn der Angebotsempfänger nicht innerhalb von fünfundvierzig (45) Tagen nach dem Zugang des Angebots beim
Angebotsempfänger mitteilt, dass er beabsichtigt, die Anteile zu erwerben, gilt dies als Ablehnung des Angebots und
Nichtausübung des Vorkaufsrechts durch den Angebotsempfänger.
(f) Wenn die in Ziffer 7.2(d) genannte Frist von fünfundvierzig (45) Tagen abläuft, ohne dass der Angebotsempfänger
seine Absicht zum Kauf der Anteile zum Ausdruck bringt, ist der Anbieter berechtigt, alle Anteile, auf die sich das Angebot
an den Geeigneten Empfänger bezieht, zu Konditionen an den Geeigneten Empfänger zu verkaufen, die nicht günstiger
sein dürfen als die Konditionen des Angebots; ein Kaufvertrag über eine geringere Zahl von Anteilen kann auf diesem
Wege nicht abgeschlossen werden.
(g) Der Angebotsempfänger kann ein Mitglied seines Konzerns zur Ausübung des Vorkaufsrechts bestellen. Zur Klar-
stellung wird darauf hingewiesen, dass Tochtergesellschaften der Anteilsinhaber / Gesellschafter des Gesellschafters zum
Konzern (die "Gruppe") im Sinne dieser Ziffer gehören.
7.3 Erstangebotsrecht
(a) Nach Ablauf von 18 Monaten ab dem 20. Juni 2014 hat jeder Gesellschafter gemäß dieser Ziffer 7.3 ein Erstange-
botsrecht bezüglich der Anteile des anderen Gesellschafters.
(b) Wenn der Anbieter beabsichtigt, ein unverbindliches Angebot über den Verkauf seiner Anteile gegenüber einem
potenziell interessierten Dritten ("Potenzieller Käufer") abzugeben, oder wenn er ein unverbindliches Angebot über den
Erwerb seiner Anteile von einem Potenziellen Käufer erhält, und der Anbieter entscheidet, diese Anteile zu verkaufen,
wird er zunächst ein Angebot über den Verkauf der Anteile an den Angebotsempfänger zu denselben Konditionen ab-
geben, zu denen er beabsichtigt, an den Potenziellen Käufer zu verkaufen. Das Angebot enthält lediglich Angaben zur
Gesamtzahl der zum Verkauf stehenden Anteile und zum Kaufpreis im Falle eines Verkaufs des Anbieters an den Po-
tenziellen Käufer.
(c) Wenn der Angebotsempfänger beabsichtigt, das Angebot anzunehmen, teilt er dies dem Anbieter innerhalb von
fünfundvierzig (45) Tagen nach dem Zugang des Angebots mit. Der Kaufvertrag zwischen dem Anbieter und dem Ange-
botsempfänger über alle Anteile, auf die sich das Angebot bezieht, kommt zustande, wenn die schriftliche Mitteilung des
Angebotsempfänger über die Annahme des Angebots dem Anbieter zugeht; ein Kaufvertrag über eine geringere Zahl von
Anteilen kann auf diesem Wege nicht abgeschlossen werden.
(d) Wenn der Angebotsempfänger nicht innerhalb von fünfundvierzig (45) Tagen nach dem Zugang des Angebots beim
Angebotsempfänger mitteilt, dass er beabsichtigt, die Anteile zu erwerben, gilt dies als Ablehnung des Angebots und
Nichtausübung des Erstangebotsrechts durch den Angebotsempfänger.
(e) Wenn die in Ziffer 7.3(d) genannte Frist von fünfundvierzig (45) Tagen abläuft, ohne dass der Angebotsempfänger
seine Absicht zum Kauf der Anteile zum Ausdruck bringt, ist der Anbieter für einen Zeitraum von sechs (6) Monaten
nach dem Zugang des Angebots beim Angebotsempfänger berechtigt, alle Anteile, auf die sich das Angebot an den Po-
tenziellen Käufer bezieht, zum Preis von mindestens 95 % des im Angebot genannten Kaufpreises und zu Konditionen,
die nicht günstiger sein dürfen als die Konditionen des Angebots an den Potenziellen Käufer (oder einen Dritten) zu
verkaufen; ein Kaufvertrag über eine geringere Zahl von Anteilen kann auf diesem Wege nicht abgeschlossen werden.
(f) Der Angebotsempfänger kann ein Mitglied seines Konzerns zur Ausübung des Erstangebotsrechts bestellen. Zur
Klarstellung wird darauf hingewiesen, dass Tochtergesellschaften der Anteilsinhaber / Gesellschafter des Gesellschafters
zum Konzern im Sinne dieser Ziffer gehören.
7.4 Konzerninterne Übertragung
(a) Ein Gesellschafter kann seine Anteile frei an ein Mitglied seines jeweiligen Konzerns übertragen. Zur Klarstellung
wird darauf hingewiesen, dass Tochtergesellschaften der Anteilsinhaber / Gesellschafter des Gesellschafters zum Konzern
im Sinne dieser Ziffer gehören.
(b) Im Falle einer Übertragung der Anteile eines Gesellschafters auf ein Konzernmitglied des betreffenden Gesell-
schafters ("Neuer Gesellschafter"), verpflichtet sich der übertragende Gesellschafter ("Zedent") zur Gewährung unmit-
telbarer Sicherheiten gegenüber dem anderen Gesellschafter im Hinblick auf die Verpflichtungen eines Neuen
Gesellschafters gemäß dieser Satzung.
(c) Der Zedent und der Neue Gesellschafter werden den anderen Gesellschafter darüber in Kenntnis setzen, wenn
der Neue Gesellschafter aus dem Konzern des Zedenten ausscheidet; der Zedent wird die betreffenden Anteile vom
Neuen Gesellschafter erwerben (bzw. die Anteile sind auf den Zedenten zurück zu übertragen, jeweils unmittelbar bevor
der Neue Gesellschafter aus dem Konzern des Zedenten ausscheidet). Verträge über die Übertragung von Anteilen an
ein Mitglied des Konzern des Gesellschafters sollen wirksame und durchsetzbare Bestimmungen enthalten, wonach der
Zedent solche Anteile vom Neuen Gesellschafter zurück erwirbt und der Neue Gesellschafter verpflichtet ist, die Anteile
an den Zedenten zu veräußern und auf diesen zurück zu übertragen, wenn der Neue Gesellschafter den Konzern des
Zedenten verlässt. Eine Übertragung von Anteilen auf ein Mitglied des Konzerns des Zedenten kann nur erfolgen, wenn
und soweit der Zedent gegenüber den anderen Gesellschaftern nachweist, dass er die Verpflichtungen gemäß dieser Ziffer
7.4 vollumfänglich erfüllt hat. Jeder Gesellschafter soll dem anderen Gesellschafter die entsprechenden Informationen
96279
L
U X E M B O U R G
überlassen, die dieser in angemessener Weise benötigt, um festzustellen, ob der Neue Gesellschafter noch Mitglied des
Konzerns des Zedenten ist.
Kapitel III. - Management
8. Geschäftsführung.
8.1 Die Gesellschaft wird von einem Geschäftsführer (der "Alleinige Geschäftsführer") oder mehreren Geschäftsfüh-
rern verwaltet. Falls mehrere Geschäftsführer ernannt wurden, besteht der Geschäftsführerrat aus diesen Geschäftsfüh-
rern (zusammen, der "Geschäftsführerrat", jeder Geschäftsführer einzeln, ein "Geschäftsführer"). Es ist nicht erforderlich
dass der Alleinige Geschäftsführer oder die Mitglieder des Geschäftsführerrates, gegebenenfalls, Gesellschafter sind.
8.2 Der Alleinige Geschäftsführer oder die Mitglieder des Geschäftsführerrates können jederzeit durch eine Entschei-
dung der außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschafter, die im Einklang mit Kapitel IV getroffen wurde,
abberufen werden.
8.3 Der Alleinige Geschäftsführer oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, der Geschäftsführerrat ist
befugt, alle Entscheidungen zu treffen, welche in Zusammenhang mit der Geschäftsführung der Gesellschaft stehen, solange
dies gemäß Artikel 12 erfolgt.
8.4 Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten vom Alleinigen Geschäftsführer, und im Falle einer Mehrzahl von Ge-
schäftsführern von je zwei Geschäftsführern vertreten und wirksam verpflichtet und dies im Einklang mit Artikel 10 der
Satzung, und gemäß Artikel 191 bis Absatz 5 des Gesetzes sind jede Urkunde, jeder Vertrag oder generell jedes Dokument,
welches in Überstimmung mit Artikel 8 und 10 der hiesigen Satzung unterzeichnet wurden, Dritten gegenüber wirksam
und bindend. Die Ausübung der Vertretungsmacht durch zwei Geschäftsführer benötigt keine vorherige Zustimmung
vom einvernehmlich handelnden Geschäftsführerrat.
8.5 Die Geschäftsführer dürfen nicht, aufgrund ihres Mandates, persönlich für etwaige gültig von Ihnen im Namen der
Gesellschaft abgeschlossene Verpflichtungen haftbar gemacht werden, vorausgesetzt diese Verpflichtungen entsprechen
der Satzung und dem Gesetz.
Unbeschadet des vorstehenden Absatzes, beträgt die Verjährungsfrist etwaiger Klagen der Gesellschaft gegen einem
Geschäftsführer ein Jahr, es sei denn es wurde eine Entscheidung von den Gesellschaftern im Einklang mit Artikel 13.9
vor dem Verfall der einjährigen Verjährungsfrist getroffen, um den Geschäftsführer, oder im Falle einer Mehrzahl von
Geschäftsführern den Geschäftsführerrat, aus seiner Haftung zu entlassen, wobei die Vollstreckbarkeit von Klagen gegen
die Geschäftsführer im Augenblick der Entlastung durch die Gesellschafter endet.
8.6 Der Alleinige Geschäftsführer, oder im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern der Geschäftsführerrat, wird
von einem Beirat unterstützt.
Der Beirat besteht aus bis zu 10 Mitgliedern formell ernannt vom Geschäftsführer oder, in Falle einer Mehrzahl von
Geschäftsführern dem Geschäftsführerrat (die "Mitglieder des Beirats" oder einzeln das "Mitglied des Beirats").
Die Mitglieder des Beirats werden durch eine transparente, die indirekte Beteiligung der Endinvestoren der Gesell-
schafter bestimmende, Prozedur festgelegt (die "Endinvestoren") (die "Indirekte Beteiligung"). Zum Zweck der Festlegung
der Indirekten Beteiligung, werden die Gesellschafter in Bezug auf das Vertretungsrecht im Beirat als transparent be-
trachtet.
Die Indirekte Beteiligung wird gemäß der folgenden Formel berechnet:
IB = G x B
Wobei:
IB = Indirekte Beteiligung
G = % der Beteiligung des jeweiligen Gesellschafters in der Gesellschaft
B = % der Beteiligung des Endinvestoren im jeweiligen Gesellschafter
Endinvestoren deren Indirekte Beteiligung 10.00% überschreitet, haben das Recht einen Vertreter in den Beirat zu
entsenden. Um jeden Zweifel auszuschließen, darf kein Endinvestor mehr als einen Vertreter im Beirat ernennen, unge-
achtet der Größe seiner Indirekten Beteiligung. Die Wahlrechte der Mitglieder des Beirats stehen den Indirekten
Beteiligungen der Endinvestoren gleich.
Es wird kein Quorum für die Sitzungen des Beirats geben, obwohl die wichtigen Entscheidungen, wie sie unter a-f
dieser Klausel 8.6 genannt werden, die Zustimmung von 60% der bestehenden Wahlrechten des Beirats benötigen. Falls
die verlangte Mehrheit von 60% der bestehenden Wahlrechte nicht erreicht wird, wird eine zweite Sitzung des Beirats
innerhalb von 20 Geschäftstagen einberufen um die vorgestellte Frage wieder zu besprechen, basierend auf weiteren zur
Verfügung gestellten Informationen und Dokumenten.
Falls die verlangte Mehrheit von 60% der bestehenden Wahlrechte des Beirats nicht in der zweiten Sitzung erreicht
wird, gilt es das Verfahren der Klausel 8.7 anzuwenden.
Der Beirat wird vorwiegend in Luxemburg zusammenkommen. Der Beirat wird auf Einladung des Alleinigen Ge-
schäftsführers oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, des Geschäftsführerrates, des Vorsitzenden des Beirats
oder einem Mitglied des Beirats zusammenkommen und tritt mindestens einmal im Jahr zusammen.
96280
L
U X E M B O U R G
Die Mitglieder des Beirats stimmen entweder schriftlich ab oder halten ihre Sitzungen per Telefon oder persönlich ab,
nachdem eine Einberufung unter Angabe der Gegenstände der Tagesordnung mit einer Frist von mindestens fünf (5)
Bankarbeitstagen erfolgt ist (es sei denn jedes Mitglied des Beirats hat schriftlich darauf verzichtet).
Stimmt der Beirat nicht schriftlich ab, wird das Protokoll der Versammlung des Beirats vom Vorsitzenden des Beirats
unterzeichnet.
Mitglieder des Beirats können Bevollmächtigte ernennen, um im Rahmen des anwendbaren Rechts Sitzungen beizu-
wohnen.
Der Beirat wird dem Alleinigen Geschäftsführer oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, dem Geschäfts-
führerrat, seine vorherige Zustimmung erteilen, bevor der Geschäftsführerrat über einen der folgenden Punkte für die
Gesellschaft entscheidet:
a) Potentielle neue Investitionen mit Ausnahme der Investitionen in die Gesellschaft;
b) Verkauf von Vermögenswerten;
c) an ihn durch den Alleinigen Geschäftsführer oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, dem Geschäfts-
führerrat, herangetragene Interessenkonflikte;
d) spezielle Angelegenheiten die, nach Entscheidung der Hauptversammlung der Gesellschafter, dem Beirat zur Ge-
nehmigung vorgelegt werden soll;
e) die Verpfändung oder Belastung des Eigentums oder eines Grundstückes, das von der Gesellschaft gehalten wird,
außer der ursprünglichen Verpfändung oder Belastung im Zusammenhang mit dem Kauf der Gesellschaft durch die Ge-
sellschafter oder solche Verpfändung oder Belastung, die für den Kauf der Gesellschaft durch die Gesellschafter nötig sein
könnte.
f) Finanzierung oder überschüssige Refinanzierung der Finanzierung der Gesellschafter im Zusammenhang mit dem
Kauf der Gesellschaft durch die Gesellschafter und back-to-back Finanzierung durch Gesellschafterdarlehen gewährt
durch die Gesellschafter (einschließlich Investec GLL Special Opportunities Real Estate Fund, FCP-FIS) an die Gesellschaft.
8.7 Ein durch den Beirat zustimmungsbedürftiges Drag Along Ereignis gilt im Hinblick auf die unter Klausel 8.6 b)
genannten Angelegenheiten als eingetreten, sobald:
i. Der Verkauf von Kapitalanlagen durch den Ablauf der Lebensdauer von GLL Retail Center I, FCP-FIS oder Investec
GLL Global Special Opportunities Real Estate Fund (die "Fonds") erforderlich ist, und
ii. Der (die) Fond(s) seine (ihre) Lebensdauer nicht verkürzt hat (haben), oder
iii. Die zweite Versammlung des Beirats keine 60% Mehrheit der abgegebenen Stimmen des Beirats im Hinblick auf die
Abstimmung über den Verkauf der jeweiligen Vermögenswerte erreicht hat.
(a) Ein Drag Along Ereignis wie unter den hier oben stehenden Punkten i.-iii. kann nicht vor dem 29. Mai 2017 eintreten.
Die Gesellschafter sind verpflichtet, sich mindestens ein Mal innerhalb des Monats nach der zweiten Versammlung zu
treffen, um das Drag Along Ereignis zu verhandeln. Falls das Drag Along Ereignis nicht vom Beirat binnen eines Monats
nach der zweiten Versammlung aufgelöst werden kann, wie unter 8.6 beschrieben (welches, um jeden Zweifel auszu-
schließen, im Falle einer Ablehnung des Beirats zur Zustimmung das Datum der Versammlung des Beirats ist oder das
Datum der Umlaufbeschlüsse des Beirats, welche das Mehrheitserfordernis aus Klausel 8.6 nicht erfüllen (sollte der
Umlaufbeschluss aus mehreren getrennten Dokumenten bestehen, so soll das Datum des letzten eingereichten Beschlus-
ses entscheidend sein)), so soll der Alleinige Geschäftsführer oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, der
Geschäftsführerrat, den Wert der Anteile bestimmen. Zu diesem Zweck soll der Alleinige Geschäftsführer oder, im Falle
einer Mehrzahl von Geschäftsführern, der Geschäftsführerrat, einen Marktwert der Anlageobjekte der Gesellschaft
("Marktwert") beschaffen. Der Alleinige Geschäftsführer oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, der Ge-
schäftsführerrat, soll dem Beirat eine Liste von mindestens drei fachkundigen, unabhängigen und seriösen externen
Gutachtern (zusammen die "Unabhängigen Gutachter" oder einzeln der "Unabhängige Gutachter") vorschlagen. Sollte
der Beirat einen einzelnen Gutachter mit einer Mehrheit von 60% der abgegebenen Stimmen ernennen, ist dieser Gut-
achter vom Alleinigen Geschäftsführer oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, dem Geschäftsführerrat,
befugt den Marktwert und somit auch den (Endgültigen) Drag Along Preis zu bestimmen. Sollte der Beirat keinen einzelnen
Unabhängigen Gutachter ernennen, so soll der Alleinige Geschäftsführer oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäfts-
führern, der Geschäftsführerrat, drei Unabhängige Gutachter beauftragen, um den Wert der Vermögensgegenstände mit
dem Durchschnitt der drei Gutachten zu bestimmen und diesen für die Bestimmung des Marktwertes und des Drag Along
Preises zu benutzen.
(b) Die Bewertung der Anteile erfolgt mittels der folgenden Formel und soll den Drag Along Preis der Anteile der
Gesellschaft bestimmen, der von den Unabhängigen Gutachtern erstellt wird (die "Drag Along Preise"):
- Das letzte IFRS Kapital angepasst an den Cash-Flow der Tätigkeiten, aber ohne die Gewinne/Verluste der Verfügungen
und nicht amortisierenden Akquisitionskosten..
- abzüglich des Buchwerts der Anlageimmobilien
- zuzüglich des Marktwerts
- abzüglich Ausschüttungen von realisierten Verfügungen
- abzüglich Verfügungen und Liquidationskosten der Gesellschaft
96281
L
U X E M B O U R G
(c) Nach der Bestimmung der Drag Along Preise und falls drei Unabhängige Gutachter ernannt worden sind, werden
die von den Unabhängigen Gutachtern aufgestellten Drag Along Preise vom Alleinigen Geschäftsführer oder, im Falle
einer Mehrzahl von Geschäftsführern, vom Geschäftsführerrat verglichen und sollten eventuelle Abweichungen unter den
ermittelten Drag Along Preisen weniger als 10.00% betragen, so soll der Endgültige Drag Along Preis der Durchschnitts-
wert aus allen drei Drag Along Preisen, wie sie von den Unabhängigen Gutachtern bestimmten worden sind, sein.
(d) Sollte die Abweichung zwischen den von den Unabhängigen Gutachtern bestimmten Drag Along Preisen mehr als
10.00% betragen, hat der Alleinige Geschäftsführer oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, der Geschäfts-
führerrat, einen vierten Unabhängigen Gutachter zu ernennen (der "Vierte Unabhängige Gutachter"), der festlegt, welcher
von den Unabhängigen Gutachtern bestimmte Drag Along Preis seiner eigenen Wertung des Drag Along Preises am
Nähesten kommt. Gemäß der Beurteilung des Vierten Unabhängigen Gutachters soll dieser Drag Along Preis der End-
gültige Drag Along Preis sein.
(e) Der Gesellschafter, für den das Drag Along Ereignis gemäß a. vorstehend bestätigt wird (der "Erste Gesellschafter")
kann dem anderen Gesellschafter (dem "Zweiten Gesellschafter") ein schriftliches Angebot vorlegen (die "Angebotsmit-
teilung"), welche einen Transfer der von dem Ersten Gesellschafter zur Zeit gehaltenen Anteile (die "Erstverkauf Anteile")
für den Endgültigen Drag Along Preis an den Zweiten Gesellschafter anbietet. Der Zweite Gesellschafter kann die An-
gebotsmitteilung annehmen oder einem Mitglied seiner Gruppe anheimstellen die Erstverkauf Anteile zu erwerben. Aus
Gründen der Klarheit, umfasst die Gruppe für den Zweck dieser Klausel auch etwaige Tochtergesellschaften der Gesell-
schafter der Gesellschafter.
(f) Der Erste Gesellschafter soll eine Kopie der Angebotsmitteilung an die Gesellschaft schicken, zeitgleich zu der
Angebotsmitteilung die an den Zweiten Gesellschafter geschickt wird.
(g) Der Zweite Gesellschafter oder das jeweilig ernannte Gruppenmitglied soll dem Ersten Gesellschafter schriftlich
binnen 20 Geschäftstagen ab Zugang der Angebotsmitteilung mitteilen, ob er die Erstverkauf Anteile gemäß der Bedin-
gungen der Angebotsmitteilung zu erwerben beabsichtigt.
(h) Sollte Zweite Gesellschafter oder das jeweilig ernannte Gruppenmitglied den Ersten Gesellschafter von seinem
Willen die Erstverkauf Anteile nach den Bedingungen der Angebotsmitteilung zu erwerben informieren, so ist der Erste
Gesellschafter verpflichtet, dem Zweiten Gesellschafter oder dem jeweilig ernannten Gruppenmitglied die Erstverkauf
Anteile zum Endgültigen Drag Along Preis zu verkaufen. Der Zweite Gesellschafter oder das jeweilig ernannte Gruppen-
mitglied haben binnen 20 Tagen ab der schriftlichen Kundgabe ihres Erwerbswillens an den Ersten Gesellschafter, dem
Ersten Gesellschafter den in der Angebotsmitteilung übermittelten Preis für die Erstverkauf Anteile zu zahlen und der
Erste Gesellschafter soll binnen 15 Geschäftstagen ab Eingang des Endgültigen Drag Along Preises dem Zweiten Gesell-
schafter oder dem jeweilig ernannten Gruppenmitglied den ordnungsgemäß ausgeführten Übergang zugunsten des
Zweiten Gesellschafters sowie den (die) Anteilsurkunde(n) der Erstverkauf Anteile zuzustellen. Der Endgültige Drag
Along Preis soll einer Post-Abschluss Preis-Anpassung unterliegen, welche auf einem geprüften IFRS Abschlussbericht
basiert.
(i) Falls der Zweite Gesellschafter dem Ersten Gesellschafter schriftlich mitteilt, die Erstverkauf Anteile nach den
Bedingungen der Angebotsmitteilung nicht erwerben zu wollen ("Negative Bekanntmachung"), beginnt die Ausgangspro-
zedur, welche das Joint Venture Agreement vorsieht, das zwischen den Gesellschaftern und Investec GLL Fund
Management Company S.A. in eigenem Namen aber für Investec GLL Global Special Opportunities Real Estate Fund
handelnd besteht ("Joint Venture Agreement").
(j) Sollte nach Ablauf der oben genannten 20 Geschäftstage der Zweite Gesellschafter noch keine schriftliche Be-
kanntmachung wie sie unter (h) vorgesehen ist an den Ersten Gesellschafter kommuniziert haben, wird der Zweite
Gesellschafter angesehen als hätte er die Angebotsmitteilung des Ersten Gesellschafters abgelehnt und die Ausgangspro-
zedur, welche das Joint Venture Agreement vorsieht, wird in Gang gesetzt.
9. Befugnisse des Geschäftsführers oder des Geschäftsführerrats.
9.1 Im Umgang mit Dritten, hat der Alleinige Geschäftsführer, oder im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, der
Geschäftsführerrat, unbeschadet der Artikel 8 bis 10 dieser Satzung alle Befugnisse, um die Gesellschaft in allen Umständen
zu vertreten und alle Geschäfte und andere Unternehmen die dem Objekt der Gesellschaft entsprechen zu verrichten.
9.2 Alle Befugnisse, welche nicht gesetzlich oder durch die Satzung der Hauptversammlung der Gesellschafter vorbe-
halten sind, fallen in die Zuständigkeit des Alleinigen Geschäftsführers, oder im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern,
des Geschäftsführerrats.
10. Vertretung der Gesellschaft. Gegenüber Dritten, wird die Gesellschaft unter allen Umständen (i) durch die Un-
terschrift des Alleinigen Geschäftsführers; (ii) im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, durch die gemeinsame
Unterschrift von jeweils zwei Geschäftsführern; oder, (iii) den Umständen entsprechend, durch die gemeinsame oder
einzelne Unterschrift(en) (einer) etwaigen Person(en) der (denen) solch eine Unterschriftsvollmacht gültig im Einklang
mit der Satzung delegiert wurde, verpflichtet sein.
11. Bevollmächtigung und bevollmächtigte des alleinigen Geschäftsführere oder des Geschäfstführerrats.
11.1 Der alleinige Geschäftsführer oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, jeweils zwei Geschäftsführer,
können ihre Befugnisse für bestimmte Aufgaben jeweils auf einen oder mehrere Ad-Hoc Bevollmächtigte übertragen.
96282
L
U X E M B O U R G
11.2 Der alleinige Geschäftsführer oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, jeweils zwei Geschäftsführer,
werden die Verpflichtungen und Vergütung (falls anwendbar), die Dauer der Vertretung sowie sonstige wesentliche Be-
dingungen der Bevollmächtigung bestimmen.
12. Geschäftsführerversammlung.
12.1 Im Falle eines Geschäftsführerrats, werden die Geschäftsführerversammlungen von jeweils einem Geschäftsführer
an einem im Einberufungsschreiben angegebenen Ort einberufen. Schriftliche Ankündigung (einschließlich durch Email)
jeder Geschäftsführerversammlung muss jedem Gesellschaftsführer mindestens achtundvierzig (48) Stunden im Voraus
kommuniziert werden, außer in dringenden Fällen, welche im Einberufungsschreiben darzulegen sind.
12.2 Sind alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten und diese geben diese an volle Kenntnis der Tagesordnung
zu besitzen, kann auf die Einberufung verzichtet werden. Auf Einberufung einer Versammlung kann von den Geschäfts-
führern ebenfalls schriftlich (einschließlich durch Email) verzichtet werden, sei es vor oder nach der Versammlung. Es
werden keine separaten Einberufungsschreiben für Versammlungen benötigt, die an Zeiten und Orten abgehalten werden,
welche in einem vorher verabschiedeten Anhang vom Geschäftsführerrat angegeben wurden, oder in einer vorherigen
Versammlung bestimmt wurden und im Versammlungsprotokoll niedergeschrieben wurden.
12.3 Jeder Gesellschafter darf in jeder Versammlung des Geschäftsführerrats agieren indem er einen anderen Ge-
schäftsführer schriftlich oder durch Telegramm, Fax, Email oder Brief als seinen Bevollmächtigten ernennt. Ein Geschäfts-
führer mag ebenfalls über Telefon einen anderen Geschäftsführer als seinen Bevollmächtigten ernennen, solange dies an
einem späteren Zeitpunkt schriftlich bestätigt wird.
12.4 Der Geschäftsführerrat bestimmt aus dem Kreis seiner Mitglieder einen Vorsitzenden (der "Vorsitzende"). Der
Vorsitzende wird jede Versammlung des Geschäftsführerrats präsidieren. In seiner Abwesenheit oder seiner Handlungs-
unfähigkeit mögen die anwesenden Geschäftsführer einen unter ihnen als Vorsitzenden der jeweiligen Versammlung
ernennen (der pro tempore Vorsitzende).
12.5 Der Geschäftsführerrat kann nur gültig beraten und agieren falls eine Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder
vertreten ist. Die Beschlüsse des Geschäftsführerrats sind gültig, falls sie von der Mehrheit seiner Mitglieder gefasst
wurden.
12.6 Das Benutzen von Videokonferenzgeräten und Telefonkonferenzen ist erlaubt, falls diese es jedem teilnehmenden
Geschäftsführer erlauben die alle andere teilnehmende Geschäftsführer zu hören und von ihnen gehört zu werden, ob
diese von dieser Technologie Gebrauch machen oder nicht, und jeder so teilnehmende Geschäftsführer werden als
anwesend betrachtet und sei die Erlaubnis besitzen per Video oder Telefon abzustimmen.
12.7 Ein schriftlicher Beschluss ist ordnungsgemäß und rechtskräftig, wenn er von allen Mitgliedern des Geschäftsfüh-
rerrats unterzeichnet wurde. Ein solcher Beschluss kann aus einem oder mehreren ähnlichen Dokumenten bestehen, die
per Fax, per Email oder ähnlichen Mitteln. Diese Beschlüsse stehen einem Beschluss, der in einer ordnungsgemäß einbe-
rufenen sowie abgehaltenen Geschäftsführerratsversammlung gefasst wurde, gleich. Schriftliche Beschlüsse werden
rechtswirksam am Tag der letzten Unterschrift eines Geschäftsführers oder, im Falle von partiell oder vollständig unda-
tierten Unterschriften, am Eingangsdatum der letzten unterschriebenen Beschlüsse am eingetragenen Sitz der Gesellschaft.
12.8 Stimmen können über Fax, Email, Telefon oder ähnliche Mittel abgegeben werden, wenn diese Abstimmung später
in Schriftform bestätigt wird. Das im Einklang mit der Satzung unterschriebene und das Abstimmungsthema dokumen-
tierende Protokoll gilt als schriftliche Bestätigung.
12.9 Das Protokoll der Geschäftsführerversammlung ist vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit, vom pro
tempore Vorsitzenden der Versammlung, oder mindestens von zwei in der Versammlung anwesenden oder vertretenen
Mitgliedern des Geschäftsführerrats zu unterschreiben. Auszüge hiervon können von einem Geschäftsführer oder einer
Person, die hiervon von einem Geschäftsführer oder während der Versammlung bevollmächtigt wurden, beurkundet
werden.
12.10 Im Falle eines Alleinigen Geschäftsführers, können die Beschlüsse des Alleinigen Geschäftsführers schriftlich
dokumentiert werden.
Kapitel IV. - Hauptversammlung der Gesellschafter
13. Befugnisse der Hauptversammlung, Einberufung und Abhärtung von Versammlungen - Abstimmungen.
13.1 Beschlüsse der Gesellschafter werden im Rahmen einer Gesellschafterversammlung (die "Hauptversammlung")
oder im Umlaufverfahren gefasst (die "Umlaufbeschlüsse ").
13.2 Sollen Umlaufbeschlüsse gefassst werden, wird der Wortlaut der Beschlüsse in satzungsgemäßer Weise an alle
Gesellschafter versandt. Umlaufbeschlüsse, die von allen Gesellschaftern unterzeichnet sind, erlangen die gleiche Gültig-
keit und Rechtskraft wie im Rahmen einer ordnungsgemäß einberufenen Hauptversammlung gefasste Beschlüsse zum
Datum der zuletzt geleisteten Unterschrift.
13.3 Jeder Anteil gewährt eine Stimme.
13.4 Die Gesellschafter werden auf Veranlassung eines Managers oder von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des
Stammkapitals repräsentieren, zu Hauptversammlungen einbestellt oder um schriftliche Stellungnahmen gebeten.
96283
L
U X E M B O U R G
13.5 Die schriftliche (auch per E-Mail) Mitteilung über eine Hauptversammlung an die Gesellschafter erfolgt mindestens
fünf (5) Tage vor der Hauptversammlung, es sei denn es liegt ein Notfall vor, dessen Art und Umstände in der Mitteilung
näher genannt werden.
13.6 Hauptversammlungen werden an dem Ort und zu dem Zeitpunkt abgehalten, die in der Einladung näher angegeben
sind.
13.7 Wenn sämtliche Gesellschafter anwesend oder ordnungsgemäß vertreten sind und sich als ordnungsgemäß ein-
geladen und über die Tagesordnung der Versammlung ausreichend informiert ansehen, kann die Gesellschafterversamm-
lung ohne vorherige Mitteilung einberufen werden.
13.8 Ein Gesellschafter kann eine anderen Person, gleich ob diese Gesellschafter ist oder nicht, schriftlich bevollmäch-
tigen, ihn bei der Hauptversammlung zu vertreten.
13.9 Unabhängig von der Anzahl der Gesellschafter sind die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung den Gesell-
schaftern zur Genehmigung vorzulegen, die ebenfalls separat darüber abstimmen sollen, ob dem alleinigen Geschäftsführer
oder, bei mehreren Geschäftsführern, der Geschäftsführung, Entlastung zu erteilen ist.
14. Alleiniger Gesellschafter.
14.1 Wenn es nur einen (1) Gesellschafter gibt, kommen dem alleinigen Gesellschafter sämtliche Befugnisse zu, die
das Gesetz über Handelsgesellschaften der Hauptversammlung verleiht.
14.2 Ein Verweis in der Satzung auf die Gesellschafter und die Gesellschafterversammlung oder Umlaufbeschlüsse sind
als Verweis auf diesen alleinigen Gesellschafter bzw. dessen Beschlüsse zu lesen.
14.3 Die Beschlüsse des Alleinigen Gesellschafters werden in einem Protokoll festgehalten oder schriftlich niedergelegt.
15. Mehrheiten.
15.1 Gemeinschaftliche Entscheidungen gelten nur dann als wirksam getroffen, wenn sie von Gesellschaftern genehmigt
werden, die mehr als die Hälfte des Stammkapitals halten. Wird diese Zahl bei der ersten Versammlung oder der ersten
schriftlichen Beratung nicht erreicht, wird durch Einschreiben an die Gesellschafter eine zweite Sitzung oder Beratung
einberufen, und Entscheidungen werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, ungeachtet des durch
diese jeweils vertretenen Kapitals.
15.2 Beschlüsse über Satzungsänderungen können nur mit einer zahlenmäßigen Mehrheit von Gesellschaftern mit
Eigentum an mehr als drei Viertel des Stammkapitals der Gesellschaft in Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes
über Handelsgesellschaften gefasst werden.
15.3 Eine Änderung der Nationalität der Gesellschaft oder eine Erhöhung der Zahl der Gesellschafter kann allerdings
nur einvernehmlich durch alle Gesellschafter und unter Einhaltung aller anderen rechtlichen Erfordernisse beschlossen
werden.
Kapitel V. - Geschäftsjahr.
16. Geschäftsjahr.
16.1 Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Tag des Monats Januar und endet am letzten Tag des Monats
Dezember eines jeden Jahres.
16.2 Am Ende eines jeden Geschäftsjahrs erstellt der alleinige Geschäftsführer bzw. bei Vorhandensein mehrerer
Geschäftsführer, die Geschäftsführung, den Jahresabschluss der Gesellschaft sowie ein Verzeichnis mit dem Wert der
Aktiva und Passiva der Gesellschaft.
16.3 Jeder Gesellschafter hat das Recht, das obige Verzeichnis und die Bilanz am Sitz der Gesellschaft einzusehen.
17. Ausschüttung des Gewinns.
17.1 Vom Nettogewinn der Gesellschaft, welcher in Übereinstimmung mit den anwendbaren rechtlichen Bestimmun-
gen ermittelt wurde, werden fünf Prozent (5%) zur Bildung der gesetzlichen Rücklage verwendet. Diese zwingende
Verpflichtung zur Bildung der Rücklage endet, wenn diese Rücklage einen Betrag erreicht hat, der einem Zehntel des
Gesellschaftskapitals entspricht.
17.2 Die Gesellschafter beschließen darüber, wie der Differenzbetrag des jährlichen Nettogewinns zu verwenden ist.
Sie können einen solchen Differenzbetrag ausschütten, in die Rücklagen einstellen oder zum Gewinnvortrag nutzen.
17.3 Die Entscheidung, Dividenden auszuschütten und die Festlegung des Betrags einer solchen Ausschüttung erfolgt
durch die Gesellschafterversammlung.
17.4 Die Geschäftsführung oder der alleinige Geschäftsführer kann, soweit das Gesetz über Handelsgesellschaften und
die Satzung dies erlaubt, auf der Grundlage des von der Geschäftsführung oder dem alleinigen Geschäftsführer erstellten
Jahresabschlusses, dem zu entnehmen ist, dass hinreichend Finanzmittel für eine Ausschüttung zur Verfügung stehen, eine
Zwischenausschüttung beschließen, wobei zu beachten ist, dass der Ausschüttungsbetrag die seit dem Ende des letzten
Geschäftsjahres erzielten Gewinne nicht überschreiten darf, erhöht um Gewinne aus Überträgen und ausschüttungsfä-
higen Rücklagen, jedoch abzüglich von Verlustvorträgen und Summen, die aufgrund Gesetzes oder dieser Satzung in die
Rücklagen einzustellen sind.
96284
L
U X E M B O U R G
Kapitel VI. - Liquidation
18. Auflösungsgründe. Die Gesellschaft wird wegen Todes, Außerkraftsetzung von Bürgerrechten, Insolvenz oder
Bankrott des alleinigen Gesellschafters oder von einem der Gesellschafter nicht aufgelöst.
19. Liquidation.
19.1 Die Liquidation der Gesellschaft kann nur beschlossen werden, wenn sie von einer Mehrheit der Gesellschafter
genehmigt wird, die mindestens drei Viertel des Stammkapitals der Gesellschaft vertreten.
19.2 Die Liquidation erfolgt durch einen oder mehrere Abwickler (liquidateur), Gesellschafter oder nicht, die von der
Hauptversammlung der Gesellschafter bestellt werden, die auch dessen bzw. deren Befugnisse und Vergütung festlegen.
19.3 Ein alleiniger Gesellschafter kann die Auflösung der Gesellschaft beschließen und ihre Liquidation veranlassen,
indem er persönlich alle bekannten und unbekannten Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft über-
nimmt.
Kapitel VII. - Geltendes recht
20. Geltendes recht. Für sämtliche Angelegenheiten, die in dieser Satzung nicht gesondert geregelt sind, wird auf die
Bestimmungen des Gesetzes über Handelsgesellschaften verwiesen.
21. Teilunwirksamkeit. Wird eine in dieser Satzung enthaltene Bestimmung von einer zuständigen Instanz für unwirk-
sam oder nicht durchsetzbar gehalten, ist diese Bestimmung durch eine Bestimmung zu ersetzen, die die für unwirksam
oder nicht durchsetzbar gehaltene Bestimmung auslegt oder einschränkt, soweit dies erforderlich ist, um die Unwirk-
samkeit oder mangelnde Durchsetzbarkeit zu beseitigen und die der ursprünglichen mit der für unwirksam oder nicht
durchsetzbar gehaltenen Bestimmung verfolgten Absicht am nächsten kommt. Die anderen Bestimmungen dieser Satzung
bleiben vollumfänglich wirksam.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Gesellschafter beschließen hiermit, dass Deloitte Luxembourg als unabhängiger Abschlussprüfer der Gesellschaft
für das kommende Geschäftsjahr bestellt wird.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar, der Englisch spricht und versteht, erklärt hiermit, dass diese Urkunde auf Wunsch der
obigen Parteien in englischer Sprache verfasst ist, und dem englischen Text eine deutsche Version folgt. Auf Wunsch
derselben erschienenen Parteien hat im Falle von Widersprüchen zwischen dem englischen und dem deutschen Text die
englische Version Vorrang.
DARAUFHIN wurde die vorliegende Urkunde an dem eingangs genannten Tag in Luxemburg errichtet.
Nach Verlesen dieser Urkunde gegenüber dem Erschienenen, hat dieser gemeinsam mit dem Notar die vorliegende
Urkunde unterzeichnet.
Gezeichnet: Henri DA CRUZ, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 30 juin 2014. Relation GRE/2014/2561. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2014096404/922.
(140114095) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2014.
Alboni Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 170.159.
L'an deux mille quatorze, le sept mai;
Pardevant Nous Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
S'est réunie
l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société “Alboni Holding S.à r.l.”, une société à responsabilité
limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1420 Luxembourg, 5,
Avenue Gaston Diderich, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro
170.159, (la “Société”), constituée suivant acte du notaire soussigné le 6 juin 2012, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations numéro 2017 du 14 août 2012,
et dont les statuts (les “Statuts”) ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant le 28 juin 2012, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2203 du 5 septembre 2012.
L'assemblée est présidée par Monsieur Claude CRAUSER, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg,
5, avenue Gaston Diderich.
96285
L
U X E M B O U R G
Le Président désigne Monsieur Brahim KORKDAN, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg, 5, ave-
nue Gaston Diderich, comme secrétaire et scrutateur.
Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter que la présente
assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jouri>
1. Refonte et reformulation des articles 14 à 19 des statuts de la Société.
2. Divers.
Ensuite l’assemblée générale extraordinaire, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale extraordinaire des associés décide de procéder à la renumérotation des articles 14 à 19 lors de
la refonte des Statuts.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide d’insérer un nouvel article 17 et de renuméroter les articles 14 à 19 en conséquence afin de refléter
l’établissement du régime de distribution de dividendes intérimaires.
L'assemblée décide que les articles 14 à 19 des Statuts auront dorénavant la teneur suivante:
Titre IV. Exercice social - Comptes annuels - Distribution des bénéfices
« Art. 14. L'année sociale commence le premier octobre de chaque année et finit le trente septembre de l’année
suivante.
Art. 15. Chaque année, le trente septembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société.
Tout associé peut prendre au siège social de la Société communication de l’inventaire et du bilan.
Art. 16. Les produits de la Société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements
et charges, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à ce que
celui-ci ait atteint dix pour cent (10%) du capital social de la Société.
Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.
Les parts sociales de la classe A donnent droit à l’attribution préférentielle et exclusive de tous les dividendes accordés
par la Société ainsi que l’attribution de la prime d'émission aux associés détenant les parts sociales de la classe A, à part
pour les dividendes qui sont exclusivement accordés aux parts sociales de la classe B et les parts sociales de la classe C,
tels que prévus ci-dessous.
Les parts sociales de la classe B donnent droit à l’attribution à titre de 84,3432% des dividendes accordés par la Société
aux associés sur base des dividendes accordés à la Société par la société par actions simplifiées OREDIS ORIENTALE ET
DISTRIBUTION, voire son successeur, liés à tous résultats et/ou réserves de la société par actions simplifiées OREDIS
ORIENTALE ET DISTRIBUTION provenant exclusivement de plus-values futures, nettes d'impôts et de taxes, ayant pour
origine la cession entière ou partielle d'actions de la société Vente-privee.com, voire ses successeurs.
Les parts sociales de la classe C donnent droit à l’attribution à titre de 15,6568% des dividendes accordées par la
Société aux associés sur base des dividendes accordés à la Société par la société par actions simplifiées OREDIS ORI-
ENTALE ET DISTRIBUTION, voire son successeur, liés à tous résultats et/ou réserves de la société par actions simplifiées
OREDIS ORIENTALE ET DISTRIBUTION provenant exclusivement de plus-values futures, nettes d'impôts et de taxes,
ayant pour origine la cession entière ou partielle d'actions de la société «Vente-privee.com» voire ses successeurs.
Art. 17. Le conseil de gérance peut distribuer des dividendes intérimaires à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) des comptes intérimaires sont établis par le conseil de gérance;
(ii) ces comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves (en ce compris la prime d'émission)
suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant
des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter
à la réserve légale;
(iii) la décision de distribuer des dividendes intérimaires doit être adoptée par les associés dans les deux (2) mois
suivant la date des comptes intérimaires;
(iv) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société; et
(v) si les dividendes intérimaires qui ont été distribués excédent les bénéfices distribuables à la fin de l’exercice social,
les associés doivent reverser l’excès à la Société.
96286
L
U X E M B O U R G
Titre V. Dissolution - Liquidation
Art. 18. En cas de dissolution de la Société, la Société sera liquidée par un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont pas besoin
d'être associés, et qui sont désignés par l’assemblée générale des associés qui détermine leurs pouvoirs et leur rémuné-
ration. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, les liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de
l’actif et le paiement du passif de la Société.
L'actif, après apurement du passif, sera partagé entre les associés en proportion de leurs parts sociales détenues dans
la Société.
Titre VI. Dispositions générales
Art. 19. Pour toute question qui n'est pas réglée par les présents Statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions
de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.»
Aucun autre point n'étant porté à l’ordre du jour de l’Assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés
ne demandant la parole, le Président a ensuite clôturé l’Assemblée.
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à 900,- EUR.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits
comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: Claude CRAUSER, Brahim KORKDAN, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 12 mai 2014. Relation GRE/2014/1885. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Junglinster, le 2 juin 2014.
Référence de publication: 2014075280/94.
(140088801) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2014.
Ateac Luxembourg, Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 87.114.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 28 juin 2013i>
- Prolongation des mandats des administrateurs avec effet au 28 juin 2013:
* Jean Baptiste ANDRIEU
* Carmen ANDRIEU THOUARD
* Jean Michel ANDRIEU
* Raphaël ANDRIEU
* Benjamin ANDRIEU
Leur mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'année 2019.
- Prolongation du mandat du commissaire avec effet au 28 juin 2013:
* SAS EZEGHIAN & AUTRES
Leur mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'année 2019.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014075324/19.
(140088529) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2014.
Anglesea Capital, Société Anonyme.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 122.777.
Par la présente je démissionne comme administrateur de votre société avec effet immédiat.
Le 27 mai 2014.
Jean Marc McLean.
Référence de publication: 2014075310/9.
(140089042) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2014.
96287
L
U X E M B O U R G
Altro, Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 2, Am Hock.
R.C.S. Luxembourg B 96.397.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 28 mai 2014.
Référence de publication: 2014075306/10.
(140089022) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2014.
Axa Alternative Financing Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 125.000,00.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 24, avenue Emile Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 118.072.
I. Par résolutions prises en date du 20 mai 2014, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Acceptation de la démission de Ian Kent, avec adresse au 47, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, de son
mandat de gérant de Catégorie B, avec effet immédiat;
2. Nomination de Maximilien Dambax, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
au mandat de gérant de Catégorie B, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée;
3. Nomination de Robert Brimeyer, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au
mandat de gérant de Catégorie B, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée;
4. Renouvellement du mandat de réviseur d'entreprises agréé de PricewaterhouseCoopers, avec siège social au 400,
Route d'Esch, L-1014 Luxembourg, pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale qui statuera sur les
comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2014 et qui se tiendra en 2015;
II. La dénomination de l'associé unique, Axa Investment Managers Private Equity, avec siège social au 20, Place Vendôme,
75001 Paris, France, a changé et est à présent Ardian.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mai 2014.
Référence de publication: 2014075293/22.
(140088989) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2014.
B.R.E. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 132.548.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 27 mai 2014i>
<i>Résolutionsi>
Les mandats des administrateurs, de l'administrateur-délégué et du commissaire aux comptes venant à échéance,
l'assemblée décide d'élire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2014 comme suit:
<i>Conseil d'administration:i>
MM. Cassinelli Umberto, demeurant au 21F Via Castagnola, CH-6900 Lugano (Suisse), administrateur et administra-
teur-délégué;
Monsieur Stefano Gusi, résidant professionnellement au 27 Via dei Priuli, 1-36015 Schio, administrateur;
Mme Gaëlle Kwiatkowski, demeurant professionnellement 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, administrateur;
<i>Commissaire aux comptes:i>
CLERC S.A., 1, Rue Pletzer, L - 8080 Bertrange
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Citco C&T (Luxembourg)
Signature
Référence de publication: 2014075335/21.
(140088945) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2014.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
96288
7H
Adamed Finance Luxembourg S.à r.l.
AddedValue S.A.
AE Lux HoldCo S.à r.l.
Agence Générale Emili et Associés S.à r.l.
Agence nationale pour le programme européen d'éducation et de formation tout au long de la vie
AI Garden Management & Cy S.C.A.
A.J.I.L. C. & P. S.A., Consultants-Courtiers en Assurances
Aktiva Fonder Sicav
Alboni Holding S.à r.l.
Alexandre Immo International S.A.
Allegro Investment Corporation S.A.
Allseas Finance S.A.
Alma Lasers S.à r.l.
Alpha Union Invest
Alpha Union Invest
Altro
ANEFORE Asbl
Anglesea Capital
Anglesea Capital
APS Consult S. à r.l.
ArcelorMittal Commercial Bars & Rods
ArcelorMittal Commercial RPS S.à r.l.
ArcelorMittal Commercial Sections S.A.
Arendt Services S.A.
Ateac Luxembourg
Axa Alternative Financing Management S.à r.l.
Bamse S.à r.l.
beeline Retail S.à r.l.
B.R.E. S.A.
CGFP Assurances
Cordonnerie Minute S.à r.l.
d'Amico International Shipping S.A.
EPI Trinity S.à r.l.
Fairfield 1 S.à r.l.
Fama International S.à r.l.
Konex
Kulturell-sportlicher Verein "BOSNA" Luxembourg
Mamer Realty Inc S.à r.l.
Premier Properties Holding S.à r.l.
Retkauf I S.à r.l.
Valcourt S.A.
Valemi Corp S.A.
Valero Moselle Company S.à r.l.
VAT Lux II S.à r.l.
VCG JL Sàrl
VCG JL Sàrl
Velcan Energy Luxembourg S.A.
Verites Vision
Vigo Internacional S.A.
Vila Verde S.à r.l.
Vilcabamba S.à r.l.
VO Consulting Lux S.A.
VPB Finance S.A.
Westbury Investments S.à r.l.
Westport Luxembourg S. à r.l.
World Café S.à r.l.
WPHD Welcome Private Hospitality Development S.A.
WWIPPS S.à r.l.
Xevin Investments S.à r.l.
YPL Consulting S.à r.l.
Zanbato Europe S.à r.l.
Zork S.A.