This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2000
30 juillet 2014
SOMMAIRE
A-Cars S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95964
Brightstar Holdings & Investments S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95966
Caisse Raiffeisen Mersch . . . . . . . . . . . . . . . .
95966
Gapi Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95994
Goodman Flame Logistics (Lux) S.à r.l. . .
95972
Goodman Harvest Logistics (Lux) S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95977
Goodman Peppermint Logistics (Lux) S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95988
Goodman Teal Logistics (Lux) S.à r.l. . . . .
95995
GREYBEX S.à r.l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95971
GSLP I Onshore S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
95992
GWE S.A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95981
GWM Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95970
IK Investment Partners S.à r.l. . . . . . . . . . .
95999
Invesco Promotions S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
95967
Lux-Tours s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95955
Magic Newco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95984
Mathur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95968
Misys Newco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95984
Select Equities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95954
Selector Management Fund . . . . . . . . . . . . .
95954
Sigma Immobilière S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
95954
Simsa S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95954
Sintesi S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95955
SL Transports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95955
Smogon S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95956
Société de Développement International
et de Capitaux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95957
Société Hôtelière de la Pétrusse S.A. . . . .
95956
Soelan S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95954
SOGEDEC, Société Générale d'Etudes et
de Coordination S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
95956
Solaia Re S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95957
Southbury Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
95958
Southbury Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
95958
Sovac 5 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95958
SPK S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95956
Sport Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95959
SSP Resources Gloucester Parent 2 S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95959
Steda s.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95959
Swiss-Lux Financial Holding S.A.H. . . . . . .
95960
Tanarive Properties S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
95959
Taranis International S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
95961
Tasman Properties S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
95960
Tatiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95957
Tatra Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
95960
Tatra S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95961
Tea Properties S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95961
Tenencia Properties S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
95962
The Kooples Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . .
95962
Tishman Speyer Junghof Holdings S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95962
Tishman Speyer Junghof LP I S.à r.l. . . . . .
95963
Tishman Speyer Junghof LP S.à r.l. . . . . . .
95963
Tishman Speyer Pacific Holdings S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95955
Tishman Speyer Pacific S.à r.l. . . . . . . . . . .
95964
TMC Immo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95958
TMF Administrative Services S.A. . . . . . . .
95965
TMF Administrative Services S.A. . . . . . . .
95960
Trafigura Funding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95966
Trafigura Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
95967
Trafigura Trade Investments (Luxem-
bourg) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95966
Transes International S.A. . . . . . . . . . . . . . .
95964
Transes Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
95965
Transports MAES International S.à r.l. . . .
95963
Turbine Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
95964
Turtle Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95963
Umwelttechnik-Tankreinigung-Tankanla-
ge-Altoelsammlung & Entsorgung . . . . . .
95962
Uni-Games S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95967
Wiltz RCG Re SCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96000
95953
L
U X E M B O U R G
Select Equities, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 156.638.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mai 2014.
<i>Pour SELECT EQUITIES
i>Banque Degroof Luxembourg S.A.
<i>Agent Domiciliatairei>
Référence de publication: 2014072540/13.
(140085154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2014.
Selector Management Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-8217 Mamer, 41, Op Bierg.
R.C.S. Luxembourg B 83.306.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2014072542/10.
(140084567) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2014.
Sigma Immobilière S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 125.000.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
SIGMA IMMOBILIERE S.à r.l.
Référence de publication: 2014072548/10.
(140084724) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2014.
Simsa S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R.C.S. Luxembourg B 65.521.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Le Conseil d'Administrationi>
Référence de publication: 2014072549/10.
(140084604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2014.
Soelan S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1143 Luxembourg, 15, rue Astrid.
R.C.S. Luxembourg B 156.986.
Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de rési-
dence à Esch/Alzette, en date du 2 décembre 2013 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 2 janvier 2014.
Référence de publication: 2014072557/11.
(140084594) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2014.
95954
L
U X E M B O U R G
Sintesi S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.
R.C.S. Luxembourg B 130.080.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
Il résulte d'un acte d'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (clôture de liquidation) de la société «SINTESI
S.C.A.», reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg), en date
du 19 mai 2014, enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 21 mai 2014. Relation: EAC/2014/7096.
- que la société «SINTESI S.C.A.» (la «Société»), société en commandite par actions, établie et ayant son siège social
au 26-28, Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg,
section B sous le numéro 130 080,
constituée suivant acte notarié dressé en date du 22 juin 2007, publié au Mémorial, Journal Officiel du Grand-Duché
de Luxembourg, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial»), numéro 1771 du 22 août 2007 à la page 84994.
Les statuts de la Société furent modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié reçu en date du 11 décembre 2007,
lequel acte fut publié au Mémorial, le 10 janvier 2008, sous le numéro 69 et page 3300,
se trouve à partir de la date du 19 mai 2014 définitivement liquidée,
l'assemblée générale extraordinaire prémentionnée faisant suite à celle du 21 octobre 2011 aux termes de laquelle la
Société a été dissoute anticipativement et mise en liquidation avec nomination d'un liquidateur, en conformité avec les
article 141 et suivants de la Loi du 10 août 1915. concernant les sociétés commerciales, telle qu'amendée, relatifs à la
liquidation des sociétés.
- que les livres et documents sociaux de la Société dissoute seront conservés pendant le délai légal (5 ans) au siège
social de la Société dissoute, en l'occurrence au 26-28, Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 22 mai 2014.
Référence de publication: 2014072551/28.
(140084735) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2014.
SL Transports, Société à responsabilité limitée,
(anc. Lux-Tours s.à r.l.).
Siège social: L-1368 Luxembourg, 26, rue du Curé.
R.C.S. Luxembourg B 37.916.
Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bascharage, le 22 mai 2014.
Référence de publication: 2014072553/10.
(140085040) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2014.
Tishman Speyer Pacific Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 177.116.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2013 de la Société, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rap-
portent, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 15 mai 2014.
Pour extrait conforme
ATOZ
Aerogolf Center - Bloc B
L-1736 Senningerberg
Signature
Référence de publication: 2014072587/16.
(140085013) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2014.
95955
L
U X E M B O U R G
Smogon S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 83.831.
Les comptes au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
SMOGON S.A.
Référence de publication: 2014072554/10.
(140084392) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2014.
Société Hôtelière de la Pétrusse S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 23, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 74.932.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue exceptionnellement le 21 mai 2014i>
Il résulte ce qui suit du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de la société tenue à
Luxembourg exceptionnellement en date du 21 mai 2014:
1) les personnes suivantes ont été réélues «Administrateurs» jusqu'à la fin de l'Assemblée Générale Ordinaire des
Actionnaires de la société de 2020:
- Luc Argand (Administrateur);
- Michaël Azoulay (Administrateur), et,
- Christophe Fasbender (Administrateur).
Les personnes suivantes forment l'ensemble du Conseil d'Administration de la société:
- Luc Argand (Administrateur);
- Michaël Azoulay (Administrateur), et,
- Christophe Fasbender (Administrateur).
2) KPMG Luxembourg S.à r.l. a été réélu «Commissaire aux comptes» de la société jusqu'à la fin de l'Assemblée
Générale Ordinaire des Actionnaires de la société de 2020.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Société Hôtelière de la Pétrusse S.A.
Référence de publication: 2014072555/23.
(140084605) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2014.
SOGEDEC, Société Générale d'Etudes et de Coordination S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2312 Luxembourg, 2A, rue de la Paix.
R.C.S. Luxembourg B 24.647.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fiduciaire Comptable B + C S.à.r.l.
Luxembourg
Référence de publication: 2014072559/11.
(140084944) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2014.
SPK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3895 Foetz, 8, rue du Commerce.
R.C.S. Luxembourg B 92.414.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 22/05/2014.
Signature.
Référence de publication: 2014072564/10.
(140084945) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2014.
95956
L
U X E M B O U R G
Société de Développement International et de Capitaux S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-8041 Strassen, 65, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 92.598.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue au siège social en date du 05 mai 2014 à 11 heuresi>
<i>Résolutionsi>
L'Assemblée décide de reconduire les mandats d'Administrateurs en fonction de:
- Madame Marie Immacolata FLORANGE;
- Madame Galina ROKOSUIEVA;
- Monsieur Jérémy STEFFEN;
L'assemblée acte également le changement d'adresse des trois administrateurs. Leur nouvelle adresse professionnelle
est la suivante: 65, Rue des Romains, L-8041 Strassen.
Les mandats d'Administrateurs sont reconduits pour une période de 6 ans et prendront fin lors de l'Assemblée Gé-
nérale Ordinaire de l'an 2020 qui statuera sur les Comptes Annuels 2019.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
L'Assemblée décide de reconduire le mandat du Commissaire en fonction de la société VAN CAUTER-SNAUWAERT
& CO SARL.
L'assemblée acte également le changement d'adresse du Commissaire. La nouvelle adresse professionnelle est la sui-
vante: 80, Rue des Romains, L-8041 Strassen.
Le mandat du Commissaire est reconduit pour une période de 6 ans et prendra fin lors de l'Assemblée Générale
Ordinaire de l'an 2020 qui statuera sur les Comptes Annuels 2019.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
S.D.I.C. Société de Développement International et de Capitaux S.A.
Référence de publication: 2014072556/27.
(140084926) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2014.
Solaia Re S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 13.000,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 134.805.
Lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 30 avril 2014, les associés ont pris les décisions suivantes:
1. Nomination de Manuela d'Amore, avec adresse au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, au mandat de gérant,
avec effet immédiat et pour une durée indéterminée;
2. Acceptation de la démission de Stefano Petroni, avec adresse au 24, In der Lau, 21335 Lüneburg, Allemagne, de son
mandat de gérant, avec effet immédiat;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 mai 2014.
Référence de publication: 2014072560/15.
(140084618) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2014.
Tatiana, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon Ier.
R.C.S. Luxembourg B 73.234.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
IF EXPERTS COMPTABLES
B.P. 1832 L-1018 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2014072599/12.
(140085066) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2014.
95957
L
U X E M B O U R G
Southbury Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 138.342.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mai 2014.
Southbury Holding S.à r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
Signature
<i>Géranti>
Référence de publication: 2014072561/14.
(140085083) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2014.
Southbury Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 138.342.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mai 2014.
Southbury Holding S.à r.l.
Manacor (Luxembourg) SA
Signature
<i>Géranti>
Référence de publication: 2014072562/14.
(140085087) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2014.
Sovac 5 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 157.965.
Il est porté à la connaissance de tout le changement d'adresse de l'associée unique de la société en la personne de
Madame Angélique Marie Bernadette Souty Sabron qui est désormais au 28, rue Sainte Anne, F-57140 Norroy le Veneur,
France.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Sovac 5 S.à r.l.
i>Fiduciaire Patrick Sganzerla S.à r.l.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2014072563/14.
(140085240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2014.
TMC Immo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1326 Luxembourg, 7, rue Auguste Charles.
R.C.S. Luxembourg B 156.151.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
L-2537 Luxembourg, le 12 mai 2014.
Monsieur Daniel Schweitzer
<i>Gérant techniquei>
Référence de publication: 2014072604/12.
(140085170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2014.
95958
L
U X E M B O U R G
Sport Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 180.664.
Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de rési-
dence à Esch/Alzette, en date du 2 décembre 2013 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 2 janvier 2014.
Référence de publication: 2014072565/11.
(140084449) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2014.
SSP Resources Gloucester Parent 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 16.020,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 149.527.
<i>Extrait des résolutions du Conseil de gérancei>
En date du 21 mai 2014, le conseil de gérance a décidé de transférer le siège social de la Société du 13-15 avenue de
la Liberté, L-1931 Luxembourg au 6 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, et ce avec effet immédiat.
Nous vous prions également de bien vouloir prendre note du changement d'adresse du gérant de classe B suivant avec
effet immédiat:
Intertrust Management (Luxembourg) S.àr.l., 6 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mai 2014.
Sophie ZINTZEN
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2014072567/18.
(140085041) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2014.
Steda s.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8510 Redange, 64, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 161.148.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014072569/10.
(140085274) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2014.
Tanarive Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 7, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 107.844.
<i>Extrait des décisions prises par l'associé unique de la Société du 19 Mai 2014i>
Le 19 mai 2014, l'associé unique de Tanarive Properties S. à r.l. a pris les résolutions suivantes:
- D'accepter la démission de Mme Christelle Ferry en qualité de Gérant de la Société avec effet au 12 mai 2014;
- De nommer Mme Séverine Canova, ayant son adresse professionnelle au 2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653
Luxembourg, en qualité de Gérant de la Société avec effet au 12 mai 2014 et pour une durée indéterminée.
Luxembourg, le 20 mai 2014.
Xavier De Cillia
<i>Géranti>
Référence de publication: 2014072572/15.
(140085189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2014.
95959
L
U X E M B O U R G
Swiss-Lux Financial Holding S.A.H., Société Anonyme.
Siège social: L-6450 Echternach, 21, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 96.272.
Les comptes annuels au 31.12.12 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014072571/9.
(140084479) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2014.
Tasman Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 7, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 109.681.
<i>Extrait des décisions prises par l'associé unique de la Société du 19 Mai 2014i>
Le 19 mai 2014, l'associé unique de Tasman Properties S. à r.l. a pris les résolutions suivantes:
- D'accepter la démission de Mme Christelle Ferry en qualité de Gérant de la Société avec effet au 12 mai 2014;
- De nommer Mme Séverine Canova, ayant son adresse professionnelle au 2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653
Luxembourg, en qualité de Gérant de la Société avec effet au 12 mai 2014 et pour une durée indéterminée.
Luxembourg, le 20 mai 2014.
Xavier De Cillia
<i>Géranti>
Référence de publication: 2014072573/15.
(140085183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2014.
Tatra Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 25.151,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 172.874.
<i>Extrait sincère et conforme des résolutions de l'associé unique du 21 mai 2014.i>
Il résulte des résolutions que M. Eddy Dôme, né le 16 août 1965 à Waremme, Belgique et résidant professionnellement
au 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg a été nommé gérant de catégorie B
avec effet à la date des résolutions et ce pour une durée Indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mai 2014.
Tatra Investments S.à r.l.
Représenté par M. Stéphane Hépineuze
<i>Gérant de catégorie Bi>
Référence de publication: 2014072574/17.
(140085198) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2014.
TMF Administrative Services S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 94.030.
Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 December 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mai 2014.
TMF Administrative Servives S.A.
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2014072606/13.
(140084839) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2014.
95960
L
U X E M B O U R G
Tatra S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: EUR 75.000,00.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.
R.C.S. Luxembourg B 134.981.
EXTRAIT
En date du 28 avril 2014, Nicolaas Johannes Alexander van ZEELAND et Michelle Marie Carvill ont démissionné de
leur fonction de gérant de la Société avec effet au 8 mai 2014.
Par résolutions d'associés prises le 8 mai 2014, il a été décidé de nommer
- Monsieur Torsten Bauer, né le 13 décembre 1963 à Sarrebruck, Allemagne, ayant son adresse professionnelle à
Sebastian-Kneipp-Allee 3, 66292 Riegelsberg, Allemagne; et
- Wisteria Investment Management S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 13 Schlappgaass,
L-9365 Eppeldorf, Grand-duché de Luxembourg, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B186524
en tant que gérants de la Société avec effet immédiat et ce, pour une durée indéterminée.
En conséquence, le conseil de gérance de la Société est désormais constitué, au 8 mai 2014, de:
- M. Torsten Bauer; et
- Wisteria Investment Management S.à r.l.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mai 2014.
Référence de publication: 2014072575/23.
(140084973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2014.
Tea Properties S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 7, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 110.577.
<i>Extrait des décisions prises par l'associé unique de la Société du 19 Mai 2014i>
Le 19 mai 2014, l'associé unique de Tea Properties S. à r.l. a pris les résolutions suivantes:
- D'accepter la démission de Mme Christelle Ferry en qualité de Gérant de la Société avec effet au 12 mai 2014;
- De nommer Mme Séverine Canova, ayant son adresse professionnelle au 2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653
Luxembourg, en qualité de Gérant de la Société avec effet au 12 mai 2014 et pour une durée indéterminée.
Luxembourg, le 20 mai 2014.
Xavier De Cillia
<i>Géranti>
Référence de publication: 2014072576/15.
(140085179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2014.
Taranis International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 45.277.
Lors du Conseil d'administration tenu le 12 mai 2014 au siège social de la société, il a été décidé:
- après lecture de la lettre de démission de Monsieur Antonio FORTE de sa fonction d'administrateur, d'accepter cette
démission.
- de coopter comme nouvel administrateur avec effet immédiat, Madame Maria-Pia BETTIOL résidant professionnel-
lement au 20, Rue de la Poste - L-2346 Luxembourg, son mandat ayant comme échéance celle de son prédécesseur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
TARANIS INTERNATIONAL S.A.
Société Anonyme
Signatures
Référence de publication: 2014072598/16.
(140084310) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2014.
95961
L
U X E M B O U R G
Tenencia Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 7, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 164.820.
<i>Extrait des décisions prises par l'associé unique de la Société du 19 Mai 2014i>
Le 19 mai 2014, l'associé unique de Tenencia Properties S. à r.l. a pris les résolutions suivantes:
- D'accepter la démission de Mme Christelle Ferry en qualité de Gérant de la Société avec effet au 12 mai 2014;
- De nommer Mme Séverine Canova, ayant son adresse professionnelle au 2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653
Luxembourg, en qualité de Gérant de la Société avec effet au 12 mai 2014 et pour une durée indéterminée.
Luxembourg, le 20 mai 2014.
Xavier De Cillia
<i>Géranti>
Référence de publication: 2014072579/15.
(140085173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2014.
The Kooples Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 8, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 93.016.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mai 2014.
Référence de publication: 2014072582/10.
(140084790) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2014.
Tishman Speyer Junghof Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 60.000,00.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 171.577.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2013 de la Société, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rap-
portent, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 15 mai 2014.
Pour extrait conforme
ATOZ
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Signature
Référence de publication: 2014072584/17.
(140085298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2014.
Umwelttechnik-Tankreinigung-Tankanlage-Altoelsammlung & Entsorgung, Société à responsabilité limi-
tée.
Siège social: L-5634 Mondorf-les-Bains, 6, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 54.613.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour UMWELTTECHNIK-TANKREINIGUNG-TANKANLAGE-ALTOELSAMMLUNG & ENTSORGUNG S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE DES PME SA
Référence de publication: 2014072614/12.
(140085081) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2014.
95962
L
U X E M B O U R G
Tishman Speyer Junghof LP I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 171.584.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2013 de la Société, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rap-
portent, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 15 mai 2014.
Pour extrait conforme
ATOZ
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Signature
Référence de publication: 2014072585/17.
(140084650) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2014.
Tishman Speyer Junghof LP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 171.583.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2013 de la Société, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rap-
portent, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 15 mai 2014.
Pour extrait conforme
ATOZ SA
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Signature
Référence de publication: 2014072586/17.
(140084584) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2014.
Transports MAES International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 67, Gruuss Strooss.
R.C.S. Luxembourg B 102.725.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, le 21/05/2014.
Référence de publication: 2014072591/10.
(140084810) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2014.
Turtle Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 166.711.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Schuttrange, le 21 mai 2014.
Référence de publication: 2014072593/10.
(140084990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2014.
95963
L
U X E M B O U R G
Tishman Speyer Pacific S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 176.176.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2013 de la Société, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rap-
portent, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 15 mai 2014.
Pour extrait conforme
ATOZ
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Signature
Référence de publication: 2014072588/17.
(140084626) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2014.
Transes International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6450 Echternach, 21, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 93.976.
Les comptes annuels au 31.12.13 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014072589/9.
(140084482) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2014.
Turbine Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 182.130.
Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de rési-
dence à Esch/Alzette, en date du 3 décembre 2013 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 3 janvier 2014.
Référence de publication: 2014072592/11.
(140084934) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2014.
A-Cars S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9907 Troisvierges, 76, rue d'Asselborn.
R.C.S. Luxembourg B 103.878.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 23/05/2014.
<i>Pour la société
i>C.F.N GESTION S.A.
20, Esplanade - L-9227 Diekirch
Adresse postale:
B.P. 80 - L-9201 Diekirch
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2014072682/17.
(140085846) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2014.
95964
L
U X E M B O U R G
Transes Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6450 Echternach, 21, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 93.994.
Les comptes annuels au 31.12.13 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014072590/9.
(140084481) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2014.
TMF Administrative Services S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 94.030.
Les décisions suivantes ont été prises et approuvées par l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société
qui s'est tenue en date du 14 mai 2014:
- d'accepter le renouvellement de Monsieur Franciscus Willem Josephine Johannes Welman, Patrick Leonardus Cor-
nelis van Denzen, Jacob Mudde, Jorge Pérez Lozano and Johannes Laurens de Zwart en tant qu'administrateurs de le
Société pour une période expirant à l'assemblée générale annuelle des actionnaires en 2017;
- d'accepter le renouvellement de PriceWaterhouseCoopers S.à r.l. en sa qualité de commissaire aux comptes de la
Société pour une période expirant à l'assemblée générale annuelle des actionnaires en 2017;
- d'accepter la démission de Monsieur Jorge Pérez Lozano en tant que administrateur-délégué de la Société avec effet
immédiat;
- de nommer en remplacement de l'administrateur-délégué démissionnaire avec effet immédiat au 14 mai 2014 Mon-
sieur Franciscus Willem Josephine Johannes Welman, né le 21 septembre 1963 à Heerlen, Pays-Bas, ayant son adresse
professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg. Son mandate expirera simultanément avec son mandat
d'administrateur;
- de confirmer que le conseil d'administration de la Société est dorénavant composé comme suit:
* Monsieur Franciscus Willem Josephine Johannes Welman;
* Monsieur Jorge Pérez Lozano;
* Monsieur Jacob Mudde;
* Monsieur Patrick Leonardus Cornelis van Denzen;
* Monsieur Johannes Laurens de Zwart;
* Madame Zora Bass;
* Monsieur Gérald Olivier David Welvaert;
* Monsieur Jean-Jacques Josset;
* Monsieur Martin Paul Galliver;
* Monsieur Fabrice Michel Gilles Mas; et
* Monsieur Fabrice Stéphane Rota.
Les décisions suivantes ont été prises et approuvées par le conseil d'administration qui s'est tenu en date du 14 mai
2014:
- d'accepter la démission de Monsieur Jorge Pérez Lozano en tant que président du conseil d'administration;
- de nommer en remplacement du président du conseil d'administration démissionnaire avec effet immédiat au 14 mai
2014 et conformément à l'article 64 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les entreprises commerciales, tel qu'amendé Monsieur
Franciscus Willem Josephine Johannes Welman, né le 21 septembre 1963 à Heerlen, Pays-Bas, ayant son adresse pro-
fessionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mai 2014.
Pour extrait sincère et conforme
TMF Luxembourg S.A.
Signatures
<i>Domiciliatairei>
Référence de publication: 2014072605/45.
(140084322) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2014.
95965
L
U X E M B O U R G
Trafigura Funding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 173.718.
EXTRAIT
Suite à un déménagement,
- Monsieur Mark Irwin, administrateur de catégorie A de la société susmentionnée, né le 28 octobre 1964 à Castle-
dawson (United Kingdom), demeure désormais professionnellement à l'adresse suivante: 3 Western Esplanade, Brighton,
BN41 1WE, United Kingdom.
- Monsieur Pierre Lorinet, administrateur de catégorie A de la société susmentionnée, né le 08 février 1972 à Chambery
(France), demeure désormais professionnellement à l'adresse suivante: 10 Collyer Quay #28-00, Ocean Financial Centre,
Singapore 049315.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Le mandatairei>
Référence de publication: 2014074239/19.
(140087295) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
Trafigura Trade Investments (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 159.363.
EXTRAIT
Suite à un déménagement,
- Monsieur Mark Irwin, gérant de catégorie A de la société susmentionnée, né le 28 octobre 1964 à Castledawson
(United Kingdom), demeure désormais professionnellement à l'adresse suivante: 3 Western Esplanade, Brighton, BN41
1WE, United Kingdom.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Le mandatairei>
Référence de publication: 2014074242/17.
(140087297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
Brightstar Holdings & Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 34.242.
Les comptes annuels au 30 juin 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014074494/9.
(140088375) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2014.
Caisse Raiffeisen Mersch, Société Coopérative.
Siège social: L-7535 Mersch, 13, rue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 20.416.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014074498/9.
(140087420) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2014.
95966
L
U X E M B O U R G
Trafigura Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 159.166.
EXTRAIT
Suite à un déménagement,
- Monsieur Mark Irwin, gérant de catégorie A de la société susmentionnée, né le 28 octobre 1964 à Castledawson
(United Kingdom), demeure désormais professionnellement à l'adresse suivante: 3 Western Esplanade, Brighton, BN41
1WE, United Kingdom.
- Monsieur Pierre Lorinet, gérant de catégorie A de la société susmentionnée, né le 08 février 1972 à Chambery
(France), demeure désormais professionnellement à l'adresse suivante: 10 Collyer Quay #28-00, Ocean Financial Centre,
Singapore 049315.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Le mandatairei>
Référence de publication: 2014074241/20.
(140087298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
Invesco Promotions S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Uni-Games S.àr.l.).
Siège social: L-1940 Luxembourg, 446A, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 111.395.
L'an deux mille quatorze, le trente avril.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
A COMPARU:
Monsieur Vittorio dit Victor VANGELISTA (actuellement inscrit auprès du RCSL comme Victor VANGELISTA), gérant
de société, demeurant à L-4930 Bascharage, 26, boulevard Kennedy, né à Pétange, le 13 janvier 1956, («l’Associé»);
ici représenté par Monsieur André PIPPIG, comptable, né le 10 juillet 1971 à Esch-sur-Alzette, demeurant profession-
nellement à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1
er
, en vertu d’une procuration donnée sous seing privée.
La prédite procuration, signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte avec lequel elle sera enregistrée.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée "UNI-GAMES S.à r.l.", avec siège social à L-1940 Luxembourg, 446A, route
de Longwy, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 111.395), a été constituée suivant acte reçu par le notaire Maître
Aloyse BIEL, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 5 octobre 2005, publié au Mémorial C numéro
302 du 10 février 2006.
- Que le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,-EUR), représenté par cent (100) parts sociales
de cent vingt-cinq euros (125,-EUR) chacune.
- Que le comparant est le seul et unique associé actuel de ladite société et qu'il a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'associé unique décide de modifier l’objet social l’article deux des statuts afin de donner la teneur suivante:
" Art. 2. La société a pour objet l’achat, la vente, la mise en valeur, la location d’immeubles et de tous droits immobiliers,
la prise, respectivement la mise en location de biens meubles et immeubles, la gérance, respectivement la gestion d’im-
meubles ou de patrimoines mobiliers et immobiliers tant pour son propre compte que pour compte de tiers, de même
que la promotion immobilière.
Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter
caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.
Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directe-
ment ou indirectement à l’objet ci-dessus et susceptibles d'en faciliter l’extension ou le développement."
95967
L
U X E M B O U R G
<i>Deuxième résolutioni>
L'associé unique décide de modifier la dénomination sociale afin de donner à l’article quatre des statuts la teneur
suivante:
" Art. 4. La société prend la dénomination de "INVESCO PROMOTIONS S.à r.l."."
<i>Evaluation des fraisi>
Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société sont évalués à la somme de huit cent cinquante
euros.
Plus rien n'étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-
meure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: André PIPPIG, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 07 mai 2014. Relation GRE/2014/1835. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME
Junglinster, le 26 mai 2014.
Référence de publication: 2014074277/51.
(140087371) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
Mathur, Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 46.760.
L'an deux mille quatorze, le douze mai.
Par devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
Se réunit
une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société de gestion de patrimoine familiale sous forme de
société anonyme MATHUR, ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, R.C.S. Luxem-
bourg section B numéro 46760, constituée par devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, suivant
acte reçu le 27 janvier 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 214 du 1
er
juin 1994,
et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu le 26 mai 2009 par-devant le notaire instrumentant,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1379 du 17 juillet 2009.
L'assemblée est présidée par Monsieur Michel PICARD, employé privé, avec adresse professionnelle au 2, avenue
Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Audrey LEITIENNE, employée privée, avec adresse professionnelle
au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Suet Sum WONG, juriste, avec adresse professionnelle au 2, avenue
Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.
Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l'acte.
II.- Il ressort de la liste de présence que les 14.000 (quatorze mille) actions d'une valeur nominale de EUR 25 (vingt-
cinq euros) chacune, représentant l'intégralité du capital social, sont représentées à la présente assemblée générale
extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les
actionnaires ont été préalablement informés.
III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification du statut de la société qui n'aura plus désormais celui d'une société de gestion de patrimoine familial
(«SPF») défini par la loi du 11 mai 2007 mais celui d'une société de participation financières («SOPARFI»).
2. Modification subséquente de l'article 4 des statuts de la société relatif à l'objet social, pour lui donner dorénavant
la teneur suivante:
95968
L
U X E M B O U R G
«La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations
sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développe-
ment de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la
liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au dévelop-
pement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat
et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire
mettre en valeur ces affaires et brevets.
Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915,
accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.
Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui
se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.»
3. Modification de l'article 1 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Il existe une société anonyme portant la dénomination de MATHUR.»
4. Modification de l'article 21 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
«La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application
partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.»
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide, avec l'accord des obligataires donné sous seing privé, d'abandonner le statut d'une société de
gestion de patrimoine familial («SPF») défini par la loi du 11 mai 2007 et d'adopter celui d'une société de participations
financières («SOPARFI»).
<i>Deuxième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 4
des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de
participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et
le développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la
liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au dévelop-
pement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat
et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire
mettre en valeur ces affaires et brevets.
Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915,
accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.
Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui
se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.»
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide de modifier l'article 1 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
« Art. 1
er
. Il existe une société anonyme portant la dénomination de MATHUR.»
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée décide de modifier l'article 21 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
« Art. 21. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur
application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille euros.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: M. PICARD, A. LEITIENNE, S. S. WONG, C. WERSANDT.
95969
L
U X E M B O U R G
Enregistré à Luxembourg A.C., le 15 mai 2014. LAC/2014/22526. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
Luxembourg, le 22 mai 2014.
Référence de publication: 2014073953/91.
(140086676) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
GWM Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1430 Luxembourg, 22, boulevard Pierre Dupong.
R.C.S. Luxembourg B 174.949.
L'an deux mille quatorze, le trente avril.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg),
s'est réunie
une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «GWM Holding S.A.», ayant son siège
social à L-1430 Luxembourg, 22, Boulevard Pierre Dupong, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Lu-
xembourg sous la section B, numéro 174.949, constituée suivant acte de constat de scission reçu par le notaire
instrumentant, en date du 3 décembre 2012, publié au Mémorial C numéro 726 en date du 26 mars 2013, et dont les
statuts n'ont pas encore été modifiés.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Sophie ERK, employée privée, demeurant professionnellement
à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
La présidente désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Antonio FERNANDES,
employé privé, demeurant professionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun
d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent
se référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.
La présidente expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Changement de l'article 5 alinéa 2 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:
« Art. 5. Alinéa 2. Les actions sont uniquement nominatives.»
2.- Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.
C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les
actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité la résolution suivante:
<i>Unique résolutioni>
L'assemblée décide de modifier l'alinéa 2 de l'article 5 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:
« Art. 5. Alinéa 2. Les actions sont uniquement nominatives.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de huit cent cinquante euros.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états et de-
meures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
95970
L
U X E M B O U R G
Signé: Sophie ERK, Antonio FERNANDES, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 06 mai 2014. Relation GRE/2014/1825. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Junglinster, le 26 mai 2014.
Référence de publication: 2014074747/54.
(140087497) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2014.
GREYBEX S.à r.l, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3960 Ehlange/Mess, 36, rue du Centre.
R.C.S. Luxembourg B 187.257.
STATUTS
L'an deux mille quatorze, le quatorze mai.
Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg,
A comparu:
Monsieur Jos Jacqué, né le 26 mai 1957 à Luxembourg, demeurant à L-3960 Ehlange / Mess, 36, rue du Centre,
ici représentée par Madame Danielle Kirsch, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé ci-annexée.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société à responsabilité limitée
qu'il déclare constituer par les présentes.
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes par le propriétaire des parts ci-après créées une société à responsabilité
limitée, qui sera régie par les lois y relatives et par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet:
- la consultation en matière de management, la restructuration de sociétés, la consultation en général.
D’une façon générale, elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se
rattachant directement ou indirectement à son objet social.
Art. 3. La société prend la dénomination de «GREYBEX S.à r.l.».
Art. 4. Le siège social est établi à Ehlange/Mess.
Art. 5. La durée de la société est illimitée.
Elle commence à compter du jour de sa constitution.
Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 12.500.- (douze mille cinq cents euros) représenté par 500 (cinq cents) parts
sociales d'une valeur nominale de EUR 25.- (vingt-cinq euros) chacune.
Art. 7. Les cessions de parts sociales sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Elles se font en
conformité avec les dispositions légales afférentes.
Art. 8. La société n'est pas dissoute par le décès d'un associé.
Art. 9. Les créanciers personnels, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit,
faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants qui sont nommés par l’assemblée générale des associés,
laquelle fixe la durée de leur mandat.
A moins que l’assemblée n'en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus
pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l’accomplissement de son objet social.
En cas de gérant unique, la société est valablement engagée vis-à-vis des tiers par la signature du gérant unique et en
cas de pluralité de gérants, les pouvoirs de signature seront déterminés par l’assemblée générale des associés/par l’associé
unique lors de la nomination des gérants.
Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire vala-
blement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Dans le cas où la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. Il ne peut
les déléguer.
95971
L
U X E M B O U R G
Les décisions de l’associé unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale, sont consignées dans un registre
tenu au siège social.
Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par lui (eux) au nom de la société.
Art. 13. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.
Art. 14. Chaque année, le trente-et-un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire com-
prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.
Art. 16. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés
nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.
Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.
Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.
Art. 18. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux
dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente-et-un décembre deux mille quatorze.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, les 500 (cinq cents) parts sociales représentatives du capital social sont
souscrites par Monsieur Jos Jacqué, prénommé, dûment représenté par Madame Danielle KIRSCH, prénommée.
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en espèce de sorte que la somme de DOUZE MILLE CINQ
CENTS EUROS (12.500.- EURO) est dès-à-présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire
qui le constate expressément.
<i>Décisions des associési>
Ensuite l’associé a pris les décisions suivantes:
1. Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
Monsieur Jos Jacqué, prénommé.
Vis-à-vis des tiers la Société est valablement engagée par la signature individuelle du gérant.
2. Le siège social est fixé à L-3960 Ehlange/Mess, 36, rue du Centre.
<i>Evaluation des frais.i>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ EUR 1.200.-.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: D. KIRSCH et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 19 mai 2014. Relation: LAC/2014/23074. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 27 mai 2014.
Référence de publication: 2014074735/85.
(140087869) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2014.
Goodman Flame Logistics (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 175.734.
In the year two thousand and fourteen, on the fifteenth day of the month of May;
Before the undersigned notary Carlo WERSANDT, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg);
THERE APPEARED:
95972
L
U X E M B O U R G
1) The private limited liability company incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg
“GELF Investments (Lux) S.à r.l.”, with registered office in L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches, registered
with the Luxembourg Trade and Companies Register section B under the number 117053; and
2) The private limited liability company incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg
“Goodman Meadow Logistics (Lux) S.à r.l.”, with registered office in L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register section B under the number 176972.
Both are here represented by Mr. Alvin SICRE, employee, residing professionally L-1160 Luxembourg, 28, boulevard
d'Avranches, (the “Proxy-holder”), by virtue of two proxies given under private seal, such proxies, after having been
signed “ne varietur” by the Proxy-holder and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to
be recorded with it.
Such appearing parties, represented as mentioned above, have requested the undersigned notary to enact the following:
- The private limited liability company incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg
“Goodman Flame Logistics (Lux) S.à r.l.”, with registered office in L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches, re-
gistered with the Luxembourg Trade and Companies Register section B under the number 175734, (the “Company”),
has been incorporated pursuant to a by a deed of the officiating notary, on February 12, 2013, published in the Memorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1051 of May 3, 2013,
and the articles of association (the “Articles”) have not been amended since;
- The appearing parties are the sole actual members of the Company (the “Members”) and they have taken, through
their Proxy-holder, the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Members decide to insert in article 7 of the Articles a restriction in the framework of transfer of shares and to
subsequently amend the second paragraph of the said article as follows:
“In case of plurality of Shareholders, the share(s) held by each Shareholder cannot be transferred without the consent
of all the other Shareholders and by application of the requirements of article 190 of the Law (the “Share Transfer
Approval”).”
<i>Second resolutioni>
The Members decide to insert a new article 8 in the Articles and to give it the following wording:
“ Art. 8. Tag-Along and Drag-Along Rights. The provisions of this Article 8 will apply in the event that, following the
Share Transfer Approval provided for in article 7, the Majority Shareholder (referred to as the “Selling Party” for the
purpose of this article 8) wishes to Transfer all or part of its Shares to a third party (the “Offered Shares”).
In case of the implementation of the Tag-Along Right or the Drag-Along Right, each party transferring Shares shall
bear its respective part of expenses and fees of counsel (including financial, legal and accounting advisors) relating to the
Transfer of the Shares and incurred in relation to the Transfer.
8.1 Transfer Notice
In the event that following the Share Transfer Approval, the Selling Party wishes to Transfer all or part of its Shares
to a third party (the “Purchaser”), the Selling Party shall send to the Minority Shareholder (referred to as the “Non-Selling
Party” for the purpose of this article 8) a notice (the “Transfer Notice”) setting out:
(a) the detailed identity of the Purchaser;
(b) the main terms and conditions of the proposed Transfer, including the price, terms of payment, representations,
warranties and indemnities; and
(c) as the case may be and if applicable, the Selling Party's intention to exercise its Drag-Along Right.
8.2 Tag-Along Right
The Non-Selling Party shall have the right to Transfer, along with the Selling Party, under the same terms and conditions
(in particular with respect to the price, terms of payment, representations, warranties and indemnities) as offered by the
Purchaser to the Selling Party, a maximum number of Shares representing the same proportion of the Shares held by the
Non-Selling Party as the proportion that the Offered Shares bear to the total number of Shares held by the Selling Party
(the “Tag-Along Right”).
The Non-Selling Party may exercise its Tag-Along Right by way of a notice to the Selling Party within twenty (20)
Business Days of receipt of the Transfer Notice (the “Tag-Along Notice”). The Tag-Along Notice will specify the number
of Shares that the Non-Selling Party wishes to Transfer in the context of its Tag-Along Right.
If the Non-Selling Party fails to submit a Tag-Along Notice during the above mentioned period, it will be deemed to
have declined to exercise its Tag-Along Right.
In the event the Non-Selling Party exercises its Tag-Along Right, the Selling Party may only Transfer the Shares referred
to in the Transfer Notice to the Purchaser provided that a number of Shares as referred to in the Tag-Along Notice are
acquired simultaneously by the Purchaser under the same terms and conditions.
8.3 Drag Along Right
95973
L
U X E M B O U R G
If the Selling Party intends to Transfer all (and not part) of its Shares to the Purchaser, the Selling Party may require
the Non-Selling Party, in the Transfer Notice, to Transfer to the Purchaser all (but not less than all) of the Shares held
by the Non-Selling Party at the same price, on the same terms and conditions as, and simultaneously with the purchase
of the Offered Shares (the “Drag-Along Right”).”
<i>Third resolutioni>
The Members also decide to create a new chapter, called “Definitions” and to place said chapter at the end of the
Articles.
The said chapter will henceforth have the following wording:
“Chapter VIII. - Definitions
“Drag Along Right” shall have the meaning set forth in article 8.3;
“Majority Shareholder” means “GELF Investments (Lux) S.à r.l.”, a private limited liability company incorporated and
existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office in L-1160 Luxembourg, 28, boulevard
d'Avranches, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register section B under the number 117053, with
a corporate capital of 1,000,000.- €;
“Minority Shareholder” means “Goodman Meadow Logistics (Lux) S.à r.l.”, a private limited liability company incor-
porated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office in L-1160 Luxembourg,
28, boulevard d'Avranches, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register section B under the number
176972, with a corporate capital of 12,500.- €;
“Non-Selling Party(ies)” shall have the meaning set forth in article 8.1;
“Offered Shares” shall have the meaning set forth in article 8;
“Purchaser” shall have the meaning set forth in article 8.1;
“Selling Party” shall have the meaning set forth in article 8.1;
“Tag-Along Notice” shall have the meaning set forth in article 8.2;
“Tag-Along Right” shall have the meaning set forth in article 8.2.”
<i>Fourth resolutioni>
The Members declare that as a result of inserting a new article 8, the current articles 8 to 17 will be renumbered into
articles 9 to 18.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand and twenty Euros
(EUR 1,020.-).
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that, on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English followed by a German version; on request of the same appearing parties,
and in case of discrepancies between the English and the German text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this docu-
ment.
The deed having been read to the Proxy-holder of the appearing parties, acting as said before, known to the notary
by his first and last name, civil status and residence, the said Proxy-holder has signed with Us, the notary, the present
original deed.
Es folgt die deutsche Fassung des vorstehenden Textes:
Im Jahr zweitausenddreizehn, am fünfzehnten Tag des Monats Mai;
Vor dem unterzeichneten Notar Carlo WERSANDT, mit Amtswohnsitz in Luxemburg, (Großherzogtum Luxemburg);
SIND ERSCHIENEN:
1) Die nach den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg gegründete und bestehende Gesellschaft mit beschränkter
Haftung „GELF Investments (Lux) S.à r.l.“, mit Sitz in L-1160 Luxemburg, 28, Boulevard d'Avranches, eingetragen in
Handelsund Firmenregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 117053; und
2) Die nach den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg gegründete und bestehende Gesellschaft mit beschränkter
Haftung „Goodman Meadow Logistics (Lux) S.à r.l.“, mit Sitz in L-1160 Luxemburg, 28, Boulevard d'Avranches, eingetragen
in Handels- und Firmenregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 176972.
Beide sind hier vertreten durch Herrn Alvin SICRE, Angestellter, beruflich wohnhaft in L-1160 Luxemburg, 28, Bou-
levard d'Avranches, (der „Bevollmächtigte“), auf Grund von zwei ihm erteilten Vollmacht unter Privatschrift, welche
95974
L
U X E M B O U R G
Vollmachten vom Bevollmächtigten und dem amtierenden Notar “ne varietur” unterschrieben, bleiben der gegenwärtigen
Urkunde beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden.
Welche erschienenen Parteien, vertreten wie hiervor erwähnt, den unterzeichneten Notar ersuchen folgendes zu
beurkunden:
- Die nach den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg gegründete und bestehende Gesellschaft mit beschränkter
Haftung „Goodman Flame Logistics (Lux) S.à r.l.“, mit Sitz in L-1160 Luxemburg, 28, Boulevard d'Avranches, eingetragen
in Handels- und Firmenregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 175734, (die “Gesellschaft”), ist gegründet
worden gemäß Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar, am 12. Februar 2013, veröffentlicht im Memorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1051 vom 3. Mai 2013,
und die Statuten (die „Statuten“) sind seitdem nicht mehr abgeändert worden;
- Die erschienenen Parteien sind die derzeitigen alleinigen Gesellschafter der Gesellschaft (die „Gesellschafter“) und
sie haben durch ihren Bevollmächtigten, folgende Beschlüsse genommen:
<i>Erster Beschlussi>
Die Gesellschafter beschließen in Artikel 7 der Statuten eine Einschränkung im Rahmen der Übertragung von Ge-
schäftsanteilen einzufügen und dementsprechend den zweiten Absatz besagten Artikels abzuändern wie folgt:
„Im Falle mehrerer Gesellschafter, dürfen die von jedem einzelnen Gesellschafter gehaltenen Gesellschaftsanteile nicht
ohne die Zustimmung aller anderen Gesellschafter und unter Anwendung der Bedingungen von Artikel 190 des Gesetztes,
abgetreten werden („Genehmigung für die Übertragung von Geschäftsanteilen“).“
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Gesellschafter beschließen einen neuen Artikel 8 in die Statuten einzuführen und ihm folgenden Wortlaut zu geben:
„ Art. 8. Mitveräußerungsrechte und -Pflichten. Die in diesem Artikel 8 vorgesehenen Regelungen kommen zur An-
wendung, wenn der Mehrheitsgesellschafter (für die Zwecke dieses Artikels 8 „veräußernder Vertragspartner“ genannt)
nach der Genehmigung für die Übertragung von Geschäftsanteilen gemäß Artikel 7 alle oder einige seiner Geschäftsanteile
auf einen Dritten übertragen möchte (die „angebotenen Geschäftsanteile“).
Im Falle der Wahrnehmung eines Mitveräußerungsrechts bzw. einer Mitveräußerungspflicht wird jeder Vertragspart-
ner, der Geschäftsanteile überträgt, die Ausgaben und Honorare, die ihm in Zusammenhang mit der Übertragung der
Geschäftsanteile für Berater (einschließlich Finanz-, Rechts und Wirtschaftsprüfungsberater) entstehen, selbst tragen.
8.1 Übertragungsmitteilung
Wenn der veräußernde Vertragspartner nach Ausstellung einer Genehmigung für die Übertragung von Geschäftsan-
teilen alle oder einige seiner Geschäftsanteile auf einen Dritten („Käufer“) übertragen möchte, wird er dem Minderheits-
gesellschafter (für die Zwecke dieses Artikels 8 „nicht veräußernder Vertragspartner“ genannt) eine Mitteilung zukommen
lassen, in der:
(a) nähere Angaben zur Identität des Käufers;
(b) die wichtigsten Bedingungen und Konditionen der vorgesehenen Übertragung, einschließlich Preis, Zahlungsmo-
dalitäten, Zusicherungen, Gewährleistungen und Freistellungen; und
(c) gegebenenfalls die Absicht des veräußernden Vertragspartners auf Einforderung der Mitveräußerungspflichten;
aufgeführt sind.
8.2 Mitveräußerungsrecht
Der nicht veräußernde Vertragspartner hat das Recht, die höchstmögliche Anzahl seiner Geschäftsanteile, die zu den
von ihm insgesamt gehaltenen Anteilen das gleiche Verhältnis aufweisen wie die angebotenen Geschäftsanteile zu der
Gesamtanzahl der von dem veräußernden Vertragspartner gehalten Anteile, zusammen mit der von dem veräußernden
Vertragspartner vorgenommenen Übertragung unter den gleichen Bedingungen und Konditionen (in Bezug auf Preis,
Zahlungsmodalitäten, Zusicherungen, Gewährleistungen und Freistellungen) ebenfalls zu übertragen („Mitveräußerungs-
recht“).
Der nicht veräußernde Vertragspartner kann sein Mitveräußerungsrecht anhand einer Nachricht an den veräußernden
Vertragspartner innerhalb von zwanzig (20) Geschäftstagen nach Erhalt der Übertragungsmitteilung wahrnehmen (die
„Mitveräußerungsnachricht“). In dieser Mitveräußerungsnachricht ist die Anzahl der Geschäftsanteile zu benennen, die
der nicht veräußernde Vertragspartner bei der Wahrnehmung seines Mitveräußerungsrechts übertragen möchte.
Legt der nicht veräußernde Vertragspartner innerhalb der vorerwähnten Frist keine Mitveräußerungsnachricht vor,
gilt, dass er sein Mitveräußerungsrecht nicht wahrzunehmen wünscht.
Nimmt der nicht veräußernde Vertragspartner sein Mitveräußerungsrecht wahr, darf der veräußernde Vertragspartner
nur die in der Übertragungsmitteilung genannten Geschäftsanteile auf den Käufer übertragen, vorausgesetzt, die in der
Mitveräußerungsnachricht genannte Anzahl an Geschäftsanteilen wird von dem Käufer unter den gleichen Bedingungen
und Konditionen gleichzeitig erworben.
8.3 Mitveräußerungspflicht
95975
L
U X E M B O U R G
Sofern der veräußernde Vertragspartner alle (und nicht nur einige) seiner Geschäftsanteile auf den Käufer übertragen
möchte, ist er berechtigt, den nicht veräußernden Vertragspartner in der Übertragungsmitteilung aufzufordern, sämtliche
(und in keinem Fall nur einige) von dem nicht veräußernden Vertragspartner gehaltenen Geschäftsanteile zum gleichen
Preis und zu gleichen Bedingungen und Konditionen zusammen mit dem Kauf der angebotenen Geschäftsanteile auf den
Käufer zu übertragen („Mitveräußerungspflicht“).“
<i>Dritter Beschlussi>
Die Gesellschafter beschließen ein neues Kapitel, genannt „Definitionen“ zu schaffen und besagtes Kapitel am Ende
der Statuten einzubringen.
Besagtes Kapitel wird fortan folgenden Wortlaut erhalten:
„Kapitel VIII. Definitionen
„Mitveräußerungspflicht“ hat die diesem Begriff in Artikel 8.3 zugewiesene Bedeutung;
„Mehrheitsgesellschafter“ bedeutet die „GELF Investments (Lux) S.à r.l.“, eine nach den Gesetzen des Großherzogtums
Luxemburg gegründete und bestehende Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Sitz in L-1160 Luxemburg, 28, Bou-
levard d'Avranches, eingetragen in Handels- und Firmenregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 117053,
mit einem Gesellschaftskapital von 1.000.000,- €;
„Minderheitsgesellschafter“ bedeutet die „Goodman Meadow Logistics (Lux) S.à r.l.“, eine nach den Gesetzen des
Großherzogtums Luxemburg gegründete und bestehende Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Sitz in L-1160 Lu-
xemburg, 28, Boulevard d'Avranches, eingetragen in Handels- und Firmenregister von Luxemburg, Sektion B, unter der
Nummer 176972, mit einem Gesellschaftskapital von 12.500,- €;
„Nicht veräußernde(r) Vertragspartner“ hat die diesem Begriff in Artikel 8.1 zugewiesene Bedeutung;
„Angebotene Geschäftsanteile“ hat die diesem Begriff in Artikel 8 zugewiesene Bedeutung;
„Käufer“ hat die diesem Begriff in Artikel 8.1 zugewiesene Bedeutung;
„Veräußernder Vertragspartner“ hat die diesem Begriff in Artikel 8.1 zugewiesene Bedeutung;
„Mitveräußerungsnachricht“ hat die diesem Begriff in Artikel 8.2 zugewiesene Bedeutung;
„Mitveräußerungsrecht“ hat die diesem Begriff in Artikel 8.2 zugewiesene Bedeutung.“
<i>Vierter Beschlussi>
Die Gesellschafterin erklären, dass infolge des Einfügens eines neuen Artikels 8, die aktuellen Artikel 8 bis 17 in Artikel
9 bis 18 um-nummeriert werde.
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr tausendzwanzig Euro
(1.020,-EUR).
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnende Notar, die die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit, dass, auf Wunsch der oben ge-
nannten erschienen Parteien, die vorliegende Urkunde in englischer Sprache verfasste wurde, gefolgt von einer deutschen
Fassung; gemäß dem Wunsch derselben Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und deutschen
Text, ist die englische Fassung maßgebend.
WORÜBER die vorliegende notarielle Urkunde in Luxemburg, an dem oben angegebenen Tag, erstellt wurde.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten der erschienenen Parteien, namens handelnd wie
hiervor erwähnt, dem amtierenden Notar nach Vor- und Zunamen, Personenstand und Wohnort bekannt, hat derselbe
Bevollmächtigte mit Uns, dem Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Signé: A. SICRE, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 20 mai 2014. LAC/2014/23228. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société;
Luxembourg, le 26 mai 2014.
Référence de publication: 2014074698/219.
(140087857) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2014.
95976
L
U X E M B O U R G
Goodman Harvest Logistics (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 175.735.
In the year two thousand and fourteen, on the fifteenth day of the month of May;
Before the undersigned notary Carlo WERSANDT, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg);
THERE APPEARED:
1) The private limited liability company incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg
“GELF Investments (Lux) S.à r.l.”, with registered office in L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches, registered
with the Luxembourg Trade and Companies Register section B under the number 117053; and
2) The private limited liability company incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg
“Goodman Meadow Logistics (Lux) S.à r.l.”, with registered office in L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register section B under the number 176972.
Both are here represented by Mr. Alvin SICRE, employee, residing professionally L-1160 Luxembourg, 28, boulevard
d'Avranches, (the “Proxy-holder”), by virtue of two proxies given under private seal, such proxies, after having been
signed “ne varietur” by the Proxy-holder and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to
be recorded with it.
Such appearing parties, represented as mentioned above, have requested the undersigned notary to enact the following:
- The private limited liability company incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg
“Goodman Harvest Logistics (Lux) S.à r.l.”, with registered office in L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register section B under the number 175735, (the “Company”),
has been incorporated pursuant to a by a deed of the officiating notary, on February 12, 2013, published in the Memorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, number 964 of April 4, 2013,
and the articles of association (the “Articles”) have not been amended since;
- The appearing parties are the sole actual members of the Company (the “Members”) and they have taken, through
their Proxy-holder, the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Members decide to insert in article 7 of the Articles a restriction in the framework of transfer of shares and to
subsequently amend the second paragraph of the said article as follows:
“In case of plurality of Shareholders, the share(s) held by each Shareholder cannot be transferred without the consent
of all the other Shareholders and by application of the requirements of article 190 of the Law (the “Share Transfer
Approval”).”
<i>Second resolutioni>
The Members decide to insert a new article 8 in the Articles and to give it the following wording:
“ Art. 8. Tag-Along and Drag-Along Rights. The provisions of this Article 8 will apply in the event that, following the
Share Transfer Approval provided for in article 7, the Majority Shareholder (referred to as the “Selling Party” for the
purpose of this article 8) wishes to Transfer all or part of its Shares to a third party (the “Offered Shares”).
In case of the implementation of the Tag-Along Right or the Drag-Along Right, each party transferring Shares shall
bear its respective part of expenses and fees of counsel (including financial, legal and accounting advisors) relating to the
Transfer of the Shares and incurred in relation to the Transfer.
8.1 Transfer Notice
In the event that following the Share Transfer Approval, the Selling Party wishes to Transfer all or part of its Shares
to a third party (the “Purchaser”), the Selling Party shall send to the Minority Shareholder (referred to as the “Non-Selling
Party” for the purpose of this article 8) a notice (the “Transfer Notice”) setting out:
(a) the detailed identity of the Purchaser;
(b) the main terms and conditions of the proposed Transfer, including the price, terms of payment, representations,
warranties and indemnities; and
(c) as the case may be and if applicable, the Selling Party's intention to exercise its Drag-Along Right.
8.2 Tag-Along Right
The Non-Selling Party shall have the right to Transfer, along with the Selling Party, under the same terms and conditions
(in particular with respect to the price, terms of payment, representations, warranties and indemnities) as offered by the
Purchaser to the Selling Party, a maximum number of Shares representing the same proportion of the Shares held by the
Non-Selling Party as the proportion that the Offered Shares bear to the total number of Shares held by the Selling Party
(the “Tag-Along Right”).
95977
L
U X E M B O U R G
The Non-Selling Party may exercise its Tag-Along Right by way of a notice to the Selling Party within twenty (20)
Business Days of receipt of the Transfer Notice (the “Tag-Along Notice”). The Tag-Along Notice will specify the number
of Shares that the Non-Selling Party wishes to Transfer in the context of its Tag-Along Right.
If the Non-Selling Party fails to submit a Tag-Along Notice during the above mentioned period, it will be deemed to
have declined to exercise its Tag-Along Right.
In the event the Non-Selling Party exercises its Tag-Along Right, the Selling Party may only Transfer the Shares referred
to in the Transfer Notice to the Purchaser provided that a number of Shares as referred to in the Tag-Along Notice are
acquired simultaneously by the Purchaser under the same terms and conditions.
8.3 Drag Along Right
If the Selling Party intends to Transfer all (and not part) of its Shares to the Purchaser, the Selling Party may require
the Non-Selling Party, in the Transfer Notice, to Transfer to the Purchaser all (but not less than all) of the Shares held
by the Non-Selling Party at the same price, on the same terms and conditions as, and simultaneously with the purchase
of the Offered Shares (the “Drag-Along Right”).”
<i>Third resolutioni>
The Members also decide to create a new chapter, called “Definitions” and to place said chapter at the end of the
Articles.
The said chapter will henceforth have the following wording:
“Chapter VIII. - Definitions
“Drag Along Right” shall have the meaning set forth in article 8.3;
“Majority Shareholder” means “GELF Investments (Lux) S.à r.l.”, a private limited liability company incorporated and
existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office in L-1160 Luxembourg, 28, boulevard
d'Avranches, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register section B under the number 117053, with
a corporate capital of 1,000,000.- €;
“Minority Shareholder” means “Goodman Meadow Logistics (Lux) S.à r.l.”, a private limited liability company incor-
porated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office in L-1160 Luxembourg,
28, boulevard d'Avranches, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register section B under the number
176972, with a corporate capital of 12,500.- €;
“Non-Selling Party(ies)” shall have the meaning set forth in article 8.1;
“Offered Shares” shall have the meaning set forth in article 8;
“Purchaser” shall have the meaning set forth in article 8.1;
“Selling Party” shall have the meaning set forth in article 8.1;
“Tag-Along Notice” shall have the meaning set forth in article 8.2;
“Tag-Along Right” shall have the meaning set forth in article 8.2.”
<i>Fourth resolutioni>
The Members declare that as a result of inserting a new article 8, the current articles 8 to 17 will be renumbered into
articles 9 to 18.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand and twenty Euros
(EUR 1,020.-).
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that, on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English followed by a German version; on request of the same appearing parties,
and in case of discrepancies between the English and the German text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this docu-
ment.
The deed having been read to the Proxy-holder of the appearing parties, acting as said before, known to the notary
by his first and last name, civil status and residence, the said Proxy-holder has signed with Us, the notary, the present
original deed.
Es folgt die deutsche Fassung des vorstehenden Textes:
Im Jahr zweitausenddreizehn, am fünfzehnten Tag des Monats Mai;
Vor dem unterzeichneten Notar Carlo WERSANDT, mit Amtswohnsitz in Luxemburg, (Großherzogtum Luxemburg);
95978
L
U X E M B O U R G
SIND ERSCHIENEN:
1) Die nach den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg gegründete und bestehende Gesellschaft mit beschränkter
Haftung „GELF Investments (Lux) S.à r.l.“, mit Sitz in L-1160 Luxemburg, 28, Boulevard d'Avranches, eingetragen in
Handelsund Firmenregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 117053; und
2) Die nach den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg gegründete und bestehende Gesellschaft mit beschränkter
Haftung „Goodman Meadow Logistics (Lux) S.à r.l.“, mit Sitz in L-1160 Luxemburg, 28, Boulevard d'Avranches, eingetragen
in Handels- und Firmenregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 176972.
Beide sind hier vertreten durch Herrn Alvin SICRE, Angestellter, beruflich wohnhaft in L-1160 Luxemburg, 28, Bou-
levard d'Avranches, (der „Bevollmächtigte“), auf Grund von zwei ihm erteilten Vollmacht unter Privatschrift, welche
Vollmachten vom Bevollmächtigten und dem amtierenden Notar “ne varietur” unterschrieben, bleiben der gegenwärtigen
Urkunde beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden.
Welche erschienenen Parteien, vertreten wie hiervor erwähnt, den unterzeichneten Notar ersuchen folgendes zu
beurkunden:
- Die nach den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg gegründete und bestehende Gesellschaft mit beschränkter
Haftung „Goodman Harvest Logistics (Lux) S.à r.l.“, mit Sitz in L-1160 Luxemburg, 28, Boulevard d'Avranches, eingetragen
in Handels- und Firmenregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 175735, (die “Gesellschaft”), ist gegründet
worden gemäß Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar, am 12. Februar 2013, veröffentlicht im Memorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 964 vom 23. April 2013,
und die Statuten (die „Statuten“) sind seitdem nicht mehr abgeändert worden;
- Die erschienenen Parteien sind die derzeitigen alleinigen Gesellschafter der Gesellschaft (die „Gesellschafter“) und
sie haben durch ihren Bevollmächtigten, folgende Beschlüsse genommen:
<i>Erster Beschlussi>
Die Gesellschafter beschließen in Artikel 7 der Statuten eine Einschränkung im Rahmen der Übertragung von Ge-
schäftsanteilen einzufügen und dementsprechend den zweiten Absatz besagten Artikels abzuändern wie folgt:
„Im Falle mehrerer Gesellschafter, dürfen die von jedem einzelnen Gesellschafter gehaltenen Gesellschaftsanteile nicht
ohne die Zustimmung aller anderen Gesellschafter und unter Anwendung der Bedingungen von Artikel 190 des Gesetztes,
abgetreten werden („Genehmigung für die Übertragung von Geschäftsanteilen“).“
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Gesellschafter beschließen einen neuen Artikel 8 in die Statuten einzuführen und ihm folgenden Wortlaut zu geben:
„ Art. 8. Mitveräußerungsrechte und -Pflichten. Die in diesem Artikel 8 vorgesehenen Regelungen kommen zur An-
wendung, wenn der Mehrheitsgesellschafter (für die Zwecke dieses Artikels 8 „veräußernder Vertragspartner“ genannt)
nach der Genehmigung für die Übertragung von Geschäftsanteilen gemäß Artikel 7 alle oder einige seiner Geschäftsanteile
auf einen Dritten übertragen möchte (die „angebotenen Geschäftsanteile“).
Im Falle der Wahrnehmung eines Mitveräußerungsrechts bzw. einer Mitveräußerungspflicht wird jeder Vertragspart-
ner, der Geschäftsanteile überträgt, die Ausgaben und Honorare, die ihm in Zusammenhang mit der Übertragung der
Geschäftsanteile für Berater (einschließlich Finanz-, Rechts und Wirtschaftsprüfungsberater) entstehen, selbst tragen.
8.1 Übertragungsmitteilung
Wenn der veräußernde Vertragspartner nach Ausstellung einer Genehmigung für die Übertragung von Geschäftsan-
teilen alle oder einige seiner Geschäftsanteile auf einen Dritten („Käufer“) übertragen möchte, wird er dem Minderheits-
gesellschafter (für die Zwecke dieses Artikels 8 „nicht veräußernder Vertragspartner“ genannt) eine Mitteilung zukommen
lassen, in der:
(a) nähere Angaben zur Identität des Käufers;
(b) die wichtigsten Bedingungen und Konditionen der vorgesehenen Übertragung, einschließlich Preis, Zahlungsmo-
dalitäten, Zusicherungen, Gewährleistungen und Freistellungen; und
(c) gegebenenfalls die Absicht des veräußernden Vertragspartners auf Einforderung der Mitveräußerungspflichten;
aufgeführt sind.
8.2 Mitveräußerungsrecht
Der nicht veräußernde Vertragspartner hat das Recht, die höchstmögliche Anzahl seiner Geschäftsanteile, die zu den
von ihm insgesamt gehaltenen Anteilen das gleiche Verhältnis aufweisen wie die angebotenen Geschäftsanteile zu der
Gesamtanzahl der von dem veräußernden Vertragspartner gehalten Anteile, zusammen mit der von dem veräußernden
Vertragspartner vorgenommenen Übertragung unter den gleichen Bedingungen und Konditionen (in Bezug auf Preis,
Zahlungsmodalitäten, Zusicherungen, Gewährleistungen und Freistellungen) ebenfalls zu übertragen („Mitveräußerungs-
recht“).
Der nicht veräußernde Vertragspartner kann sein Mitveräußerungsrecht anhand einer Nachricht an den veräußernden
Vertragspartner innerhalb von zwanzig (20) Geschäftstagen nach Erhalt der Übertragungsmitteilung wahrnehmen (die
95979
L
U X E M B O U R G
„Mitveräußerungsnachricht“). In dieser Mitveräußerungsnachricht ist die Anzahl der Geschäftsanteile zu benennen, die
der nicht veräußernde Vertragspartner bei der Wahrnehmung seines Mitveräußerungsrechts übertragen möchte.
Legt der nicht veräußernde Vertragspartner innerhalb der vorerwähnten Frist keine Mitveräußerungsnachricht vor,
gilt, dass er sein Mitveräußerungsrecht nicht wahrzunehmen wünscht.
Nimmt der nicht veräußernde Vertragspartner sein Mitveräußerungsrecht wahr, darf der veräußernde Vertragspartner
nur die in der Übertragungsmitteilung genannten Geschäftsanteile auf den Käufer übertragen, vorausgesetzt, die in der
Mitveräußerungsnachricht genannte Anzahl an Geschäftsanteilen wird von dem Käufer unter den gleichen Bedingungen
und Konditionen gleichzeitig erworben.
8.3 Mitveräußerungspflicht
Sofern der veräußernde Vertragspartner alle (und nicht nur einige) seiner Geschäftsanteile auf den Käufer übertragen
möchte, ist er berechtigt, den nicht veräußernden Vertragspartner in der Übertragungsmitteilung aufzufordern, sämtliche
(und in keinem Fall nur einige) von dem nicht veräußernden Vertragspartner gehaltenen Geschäftsanteile zum gleichen
Preis und zu gleichen Bedingungen und Konditionen zusammen mit dem Kauf der angebotenen Geschäftsanteile auf den
Käufer zu übertragen („Mitveräußerungspflicht“).
<i>“Dritter Beschlussi>
Die Gesellschafter beschließen ein neues Kapitel, genannt „Definitionen“ zu schaffen und besagtes Kapitel am Ende
der Statuten einzubringen.
Besagtes Kapitel wird fortan folgenden Wortlaut erhalten:
„Kapitel VIII. Definitionen
„Mitveräußerungspflicht“ hat die diesem Begriff in Artikel 8.3 zugewiesene Bedeutung;
„Mehrheitsgesellschafter“ bedeutet die „GELF Investments (Lux) S.à r.l.“, eine nach den Gesetzen des Großherzogtums
Luxemburg gegründete und bestehende Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Sitz in L-1160 Luxemburg, 28, Bou-
levard d'Avranches, eingetragen in Handels- und Firmenregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 117053,
mit einem Gesellschaftskapital von 1.000.000,- €;
„Minderheitsgesellschafter“ bedeutet die „Goodman Meadow Logistics (Lux) S.à r.l.“, eine nach den Gesetzen des
Großherzogtums Luxemburg gegründete und bestehende Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Sitz in L-1160 Lu-
xemburg, 28, Boulevard d'Avranches, eingetragen in Handels- und Firmenregister von Luxemburg, Sektion B, unter der
Nummer 176972, mit einem Gesellschaftskapital von 12.500,- €;
„Nicht veräußernde(r) Vertragspartner“ hat die diesem Begriff in Artikel 8.1 zugewiesene Bedeutung;
„Angebotene Geschäftsanteile“ hat die diesem Begriff in Artikel 8 zugewiesene Bedeutung;
„Käufer“ hat die diesem Begriff in Artikel 8.1 zugewiesene Bedeutung;
„Veräußernder Vertragspartner“ hat die diesem Begriff in Artikel 8.1 zugewiesene Bedeutung;
„Mitveräußerungsnachricht“ hat die diesem Begriff in Artikel 8.2 zugewiesene Bedeutung;
„Mitveräußerungsrecht“ hat die diesem Begriff in Artikel 8.2 zugewiesene Bedeutung.“
<i>Vierter Beschlussi>
Die Gesellschafterin erklären, dass infolge des Einfügens eines neuen Artikels 8, die aktuellen Artikel 8 bis 17 in Artikel
9 bis 18 um-nummeriert werde.
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr tausendzwanzig Euro
(1.020,-EUR).
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnende Notar, die die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit, dass, auf Wunsch der oben ge-
nannten erschienen Parteien, die vorliegende Urkunde in englischer Sprache verfasste wurde, gefolgt von einer deutschen
Fassung; gemäß dem Wunsch derselben Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und deutschen
Text, ist die englische Fassung maßgebend.
WORÜBER die vorliegende notarielle Urkunde in Luxemburg, an dem oben angegebenen Tag, erstellt wurde.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten der erschienenen Parteien, namens handelnd wie
hiervor erwähnt, dem amtierenden Notar nach Vor- und Zunamen, Personenstand und Wohnort bekannt, hat derselbe
Bevollmächtigte mit Uns, dem Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Signé: A. SICRE, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 20 mai 2014. LAC/2014/23227. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
95980
L
U X E M B O U R G
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société;
Luxembourg, le 26 mai 2014.
Référence de publication: 2014074700/219.
(140087749) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2014.
GWE S.A, Société Anonyme.
Siège social: L-6791 Grevenmacher, 22, route de Thionville.
R.C.S. Luxembourg B 187.267.
STATUTEN
Im Jahre zweitausendvierzehn,
Am zweiunzwanzigsten Mai,
Vor dem unterzeichneten Notar Jacques CASTEL, mit dem Amtswohnsitz zu Grevenmacher.
Ist erschienen:
Herr Michael BREMER, Steuer- und Wirtschaftsjurist, geboren in Lüdenscheid (Deutschland) am 8. Juni 1958, wohnhaft
in L-5401 Ahn, 2, rue de Niederdonven.
Welcher Komparent den unterzeichneten Notar ersucht die Satzung einer von Ihm zu gründenden Aktiengesellschaft
wie folgt zu beurkunden:
Titel I - Name, Sitz, Zweck, Dauer.
Art. 1. Es besteht eine luxemburgische Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung „GWE S.A.“
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Grevenmacher.
Er darf durch Verwaltungsratsbeschluss an jeden anderen Ort innerhalb der Gemeinde Grevenmacher verlegt werden.
Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer oder wirtschaftlicher Natur eintreten oder bevorstehen, welche geei-
gnet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz
und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur endgültigen Wiederherstellung
normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden. Dieser Beschluss soll jedoch die luxemburgische Staatsangehörigkeit
nicht beeinflussen. Die Sitzverlegung soll Drittpersonen durch das Organ der Gesellschaft mitgeteilt werden, welches
unter den gegebenen Umständen hierzu am besten befähigt ist.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Art. 4. Die Gesellschaft hat zum Zweck:
- Steuerberatung im Rahmen der Erlaubnis des Comptables;
- Vergabe von Lizenzen.
Gegenstand der Gesellschaft ist die Verwaltung und Vermarktung von Markenrechten, Lizenzen, Urheberrechten und
Ähnlichem.
Insbesondere kann die Gesellschaft die Mittel für die Erstellung, Verwaltung, Entwicklung und Verwertung eines Port-
folios, welches alle Arten von Wertpapieren oder Patenten gleich welcher Herkunft, bereitstellen, sich an der Gründung,
Entwicklung und Kontrolle aller Unternehmen beteiligen, alle Wertpapiere und Patente, entweder durch Einlage, Zeich-
nung, Kauf oder anderweitig erwerben oder diese durch Verkauf, Übertragung, Tausch oder auf andere Art veräußern.
Die Gesellschaft kann auf eigene Rechnung oder im Namen von Dritten alle Geschäfte betreiben, die der Erreichung
ihres Zweckes förderlich sind oder direkt oder indirekt mit diesem Zweck verbunden sind.
Die Gesellschaft ist ermächtigt, diese Tätigkeiten sowohl im Großherzogtum Luxemburg wie auch im Ausland auszu-
führen.
Sie kann generell jegliche kommerzielle, industrielle, mobiliare, immobiliare oder finanzielle Transaktionen ausführen,
sowie auch Dienstleistungen erbringen, dies sowohl im Großherzogtum Luxemburg wie auch im Ausland, sowie alle
Transaktionen ausführen, welche der Erfüllung ihres Gesellschaftszweckes dienen.
Titel II - Kapital, Aktien.
Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreißigtausend Euro (31.000.- EUR), eingeteilt in dreihundertzehn (310)
Aktien mit einem Nennwert von jeweils einhundert Euro (100.- EUR).
An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der
Aktionäre.
Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.
Die Gesellschaft darf im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ihre eigenen Aktien erwerben.
Das Gesellschaftskapital darf den gesetzlichen Bedingungen entsprechend erhöht oder reduziert werden.
95981
L
U X E M B O U R G
Sofern und solange ein Gesellschafter alleiniger Inhaber aller Aktien ist, gilt die Gesellschaft als Einmannaktiengesell-
schaft im Sinne des Gesetzes vom 25. August 2006 über die europäische Gesellschaft (SE), die Aktiengesellschaft mit
Vorstand und Aufsichtsrat („société anonyme à directoire et conseil de surveillance“) und die Einmannaktiengesellschaft
(„société anonyme unipersonnelle“). Zählt die Gesellschaft nur eine Person, so wird diese als Alleingesellschafter be-
zeichnet. Die Gesellschaft kann einen Alleingesellschafter bei ihrer Gründung oder als Folge der Vereinigung sämtlicher
Aktien in einer Hand haben. Das Ableben oder die Auflösung des Alleingesellschafters bewirkt nicht die Auflösung der
Gesellschaft.
Titel III - Verwaltung.
Art. 6. Die Gesellschaft wird verwaltet von einem Verwaltungsrat bestehend aus mindestens drei Mitgliedern, Gesell-
schafter oder nicht, welche für eine Höchstdauer von sechs Jahren von der Generalversammlung der Aktionäre ernannt
werden und von ihr wieder abberufen werden können.
Besteht die Gesellschaft jedoch nur aus einem Alleingesellschafter oder wird anlässlich einer Generalversammlung der
Aktionäre festgestellt, dass sie nur noch einen Alleingesellschafter zählt, kann die Zusammensetzung des Verwaltungsrats
auf ein Mitglied beschränkt werden, welches als Alleinverwalter („administrateur unique“) bezeichnet wird, dies bis zur
nächsten auf die Feststellung der Existenz von mehr als einem Gesellschafter folgenden ordentlichen Generalversammlung.
Sie bestimmt die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder, ihre Amtszeit und ihre Vergütung.
Art. 7. Der Verwaltungsrat ernennt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden; in dessen Abwesenheit kann der
Vorsitz einer Verwaltungsratssitzung einem Verwaltungsratsmitglied übertragen werden. Auf Antrag des Vorsitzenden
kommt der Verwaltungsrat so oft zusammen, wie es das Interesse der Gesellschaft erfordert. Er muss zusammenkommen,
wenn zwei Verwaltungsratsmitglieder dies verlangen.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist; die
Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch oder per elek-
tronische Post erfolgen kann, ist gestattet.
In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm, Telekopie oder elektronische
Post erfolgen.
Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit entscheidet die
Stimme des Vorsitzenden.
Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Ver-
tretung der Gesellschaft an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere
Bevollmächtigte übertragen; dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein.
Falls sich der Verwaltungsrat auf einen Alleinverwalter beschränkt, ist dieser Artikel nicht anwendbar.
Art. 8. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Verwaltungs- und Veräußerungshandlungen im
Rahmen des Gesellschaftszweckes vorzunehmen. Alles was nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder die gegenwärtige
Satzung der Generalversammlung der Aktionäre vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, unter den gesetzlichen Bedingungen Vorschüsse auf Dividenden auszuzahlen.
Art. 9. Die Gesellschaft wird rechtsverbindlich vertreten durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungs-
ratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift des delegierten Verwaltungsratsmitgliedes.
Falls die Gesellschaft einen Alleinverwalter hat, wird sie durch dessen Einzelunterschrift verpflichtet.
Art. 10. Der Verwaltungsrat darf seine Befugnisse zur Führung der täglichen Geschäftsführung einem oder mehreren
Verwaltungsratsmitgliedern, welche delegierte Verwaltungsratsmitglieder genannt werden, übertragen.
Er darf ebenfalls die Führung der Gesellschaft oder einer Einzelabteilung einem oder mehreren Direktoren übertragen
und Spezialvollmachten für bestimmte Angelegenheiten einem oder mehreren Bevollmächtigen erteilen; dieselben brau-
chen nicht Aktionäre zu sein.
Art. 11. Streitfälle, an denen die Gesellschaft als Kläger oder Beklagter beteiligt ist, werden im Namen der Gesellschaft
vom Verwaltungsrat abgewickelt, welcher durch seinen Vorsitzenden oder durch das speziell für diesen Zweck bestimmte
Verwaltungsratsmitglied vertreten wird.
Titel IV - Aufsicht.
Art. 12. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche die Generalversammlung
der Aktionäre ernennt. Die Generalversammlung bestimmt außerdem ihre Zahl und ihre Vergütung sowie ihre Amtszeit,
welche sechs Jahre nicht überschreiten darf.
Titel V - Generalversammlung.
Art. 13. Die jährliche Generalversammlung findet rechtens statt am ersten Montag des Monats August um 14.00 Uhr,
am Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort.
Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Generalversammlung am ersten darauf folgenden Werktag statt.
95982
L
U X E M B O U R G
Sofern die Gesellschaft einen Alleingesellschafter zählt, übt dieser die der Generalversammlung der Aktionäre zufal-
lenden Befugnisse aus.
Titel VI - Geschäftsjahr, Gewinnverteilung.
Art. 14. Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom 1. Januar bis zum 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 15. Der positive Saldo der Gewinn- und Verlustrechnung nach Abzug der allgemeinen Unkosten und der Abs-
chreibungen bildet den Reingewinn der Gesellschaft. Jedes Jahr werden fünf Prozent des Reingewinns vorweggenommen
und der gesetzlichen Rücklage zugeführt. Diese Vorwegnahmen und Zuführungen sind nicht mehr zwingend vorgeschrie-
ben, wenn die Rücklage zehn Prozent des Kapitals erreicht hat, müssen jedoch wieder einsetzen bis zu seiner vollständigen
Wiederherstellung, wenn der Rücklagefonds zu einem gegeben Zeitpunkt aus welchem Grund auch immer in Anspruch
genommen worden ist.
Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.
Titel VII - Auflösung, Liquidation.
Art. 16. Die Gesellschaft kann durch einen Generalversammlungsbeschluss der Aktionäre aufgelöst werden. Ein oder
mehrere Liquidatoren, natürliche oder juristische Personen, ernannt von der Generalversammlung der Aktionäre, welche
ihre Befugnisse und Vergütungen bestimmt, führen die Liquidation durch.
Titel VIII - Allgemeine Bestimmungen.
Art. 17. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, einschließlich der
Änderungsgesetze, finden ihre Anwendung überall wo gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.
<i>Übergangsbestimmungen.i>
1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 2014.
2) Die erste jährliche Hauptversammlung findet in 2015 statt.
<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktien.i>
Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklärt der Alleingesellschafter die Aktien wie folgt zu zeichnen:
Unterzeichner
Anzahl
Aktien
Gezeichnetes
und
eingezahltes
Kapital
Michael BREMER, vorgenannt, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310
31.000.-
TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310
31.000.-
Sämtliche Aktien wurden in bar eingezahlt; demgemäß verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über einen
Betrag von einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000,-), wie dies dem Notar nachgewiesen wurde.
<i>Erklärung.i>
Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26-1 und Artikel 263 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die
Handelsgesellschaften vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.
<i>Schätzung der Gründungskosten.i>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr eintausenddreihundert (1.300.-) Euro.
<i>Ausserordentliche Hauptversammlung.i>
Sodann erklärt der alleinige Gesellschafter, handelnd an Stelle einer außerordentlichen Hauptversammlung, folgende
Beschlüsse zu nehmen:
1) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich L-6791 Grevenmacher, 22, route de Thionville.
2) Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf eins, die der Kommissare auf eins festgesetzt.
3) Zum alleinigen Verwaltungsratsmitglied wird ernannt:
Herr Michael BREMER, Steuer- und Wirtschaftsjurist, geboren in Lüdenscheid (Deutschland) am 8. Juni 1958, wohnhaft
in L-5401 Ahn, 2, rue de Niederdonven.
4) Zum Kommissar wird ernannt:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung «LUXREVISION S.à r.l.», mit Sitz in L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch,
eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 40124.
5) Die Mandate des alleinigen Verwaltungsratsmitgliedes und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Haupt-
versammlung von 2019.
95983
L
U X E M B O U R G
Vor Abschluss der gegenwärtigen Urkunde hat der unterzeichnete Notar auf die Notwendigkeit hingewiesen die
administrative Genehmigung zu erhalten, zwecks Ausübung des Gesellschaftsgegenstandes.
WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen wurde zu Grevenmacher, Datum wie eingangs erwähnt,
Und nach Vorlesung an den dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannten
Komparenten, hat derselbe mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: M. BREMER, J. CASTEL.
Enregistré à Grevenmacher, le 23 mai 2014. Relation: GRE/2014/2118. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): Schlink.
FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung auf dem Handels- und Gesellschaftsregister, und
zwecks Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.
Grevenmacher, den 27. Mai 2014.
J. CASTEL.
Référence de publication: 2014074746/166.
(140088188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2014.
Misys Newco S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Magic Newco S.à r.l.).
Capital social: USD 842.135.381,00.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 167.479.
In the year two thousand and fourteen, on the fourteenth day of April.
Before us Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
(1) Tahoe Cayman Ltd., a limited liability company, incorporated and existing under the laws of the Cayman Islands,
having its registered office at Ugland House, KY-KY1-1104 Grand Cayman, Cayman Islands,
here represented by Louis Servajean-Hilst, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given on 14
April 2014, and
(2) Misys Manco S.C.A. (formerly Tahoe Manco S.C.A.), a société en commandite par actions incorporated and existing
under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under registration number
B 166514 (“Manco”),
here represented by Louis Servajean-Hilst, prenamed, by virtue of a proxy, given on 14 April 2014,
which proxies, after having been signed “ne varietur” by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain
attached to this deed in order to be registered therewith.
Such appearing parties are all the shareholders of Misys Newco S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated
and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of eight million three hundred and
eighty-seven thousand eight hundred and seventy-seven United States Dollars and twenty-three cents of an United States
Dollar (USD 8,387,877.23), having its registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 167479, incorporated
pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 13
March 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 755 on 22 March 2012 (hereafter
the "Company"). The articles of incorporation were amended for the last time pursuant to a deed of Maître Henri
Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg on 27 March 2013, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations number 1419 of 14 June 2013.
The appearing parties, representing the entire share capital, requested the undersigned notary to act that the agenda
of the meeting is as follows:
<i>Agendai>
1. Increase of the Company’s share capital by an amount of thirty-three thousand four hundred seventy-six United
States Dollars and fifty-eight Cents of a United States Dollar (USD 33,476.58) in order to bring it from its current amount
of eight million three hundred eighty-seven thousand eight hundred seventy-seven United States Dollars and twenty three
Cents of an United States Dollar (USD 8,387,877.23) up to a new amount of eight million four hundred twenty-one
thousand three hundred fifty-three United States Dollars and eighty-one Cents of an United States Dollar (USD
8,421,353.81) through the issuance of (i) seven hundred forty-three thousand eight hundred eighty-six (743,886) class B1
shares of the Company with a par value of one Cent of an United States Dollar (USD 0.01) each, (ii) seven hundred forty-
three thousand eight hundred eighty-six (743,886) class B2 shares of the Company with a par value of one Cent of an
United States Dollar (USD 0.01) each, (iii) seven hundred forty-three thousand eight hundred eighty-six (743,886) class
95984
L
U X E M B O U R G
B3 shares of the Company with a par value of one Cent of an United States Dollar (USD 0.01) each, (iv) three hundred
seventy-two thousand (372,000) class C1 shares of the Company with a par value of one Cent of an United States Dollar
(USD 0.01) each, (v) three hundred seventy-two thousand (372,000) class C2 shares of the Company with a par value of
one Cent of an United States Dollar (USD 0.01) each, and (vi) three hundred seventy-two thousand (372,000) class C3
shares of the Company with a par value of one Cent of an United States Dollar (USD 0.01) each; and
2. Corresponding amendment of article 5.1. of the Company’s articles of association.
The appearing party, representing the entire share capital, took the following resolutions:
<i>First resolution:i>
The shareholders resolve to increase the Company’s share capital by an amount of thirty-three thousand four hundred
seventy-six United States Dollars and fifty-eight Cents of an United States Dollar (USD 33,476.58) in order to bring it
from its current amount of eight million three hundred eighty-seven thousand eight hundred seventy-seven United States
Dollars and twenty-three Cents of an United States Dollar (USD 8,387,877.23) up to eight million four hundred twenty-
one thousand three hundred fifty-three United States Dollars and eighty-one Cents of an United States Dollar (USD
8,421,353.81) through the issuance of (i) seven hundred forty-three thousand eight hundred eighty-six (743,886) new
Class B1 shares of the Company with a par value of one Cent of an United States Dollar (USD 0.01) each, (ii) seven
hundred forty-three thousand eight hundred eighty-six (743,886) new Class B2 shares of the Company with a par value
of one Cent of an United States Dollar (USD 0.01) each, (iii) seven hundred forty-three thousand eight hundred eighty-
six (743,886) new Class B3 shares of the Company with a par value of one Cent of an United States Dollar (USD 0.01)
each, (iv) three hundred seventy-two thousand (372,000) new Class C1 shares of the Company with a par value of one
Cent of an United States Dollar (USD 0.01) each, (v) three hundred seventy-two thousand (372,000) new Class C2 shares
of the Company with a par value of one Cent of an United States Dollar (USD 0.01) each and (vi) three hundred seventy-
two thousand (372,000) new Class C3 shares of the Company with a par value of one Cent of an United States Dollar
(USD 0.01) each.
All of the (i) seven hundred forty-three thousand eight hundred eighty-six (743,886) new class B1 shares, (ii) seven
hundred forty-three thousand eight hundred eighty-six (743,886) new class B2 shares, (iii) seven hundred forty-three
thousand eight hundred eighty-six (743,886) new class B3 shares, (iv) three hundred seventy-two thousand (372,000)
new class C1 shares, (v) three hundred seventy-two thousand (372,000) new class C2 shares and (vi) three hundred
seventy-two thousand (372,000) new class C3 shares, have been subscribed by Manco, prenamed, here represented as
aforementioned, and have been fully paid up in cash, so that the amount of thirty-three thousand four hundred and seventy-
six United States Dollars and twenty-three Cents of an United States Dollar (USD 33,476.58) is as now available to the
company as has been proved to the undersigned notary.
<i>Second resolution:i>
As a consequence of the foregoing resolution, the shareholders resolve to amend article 5.1. of the Company’s articles
of association in order to read as follows:
“ 5.1. The Company’s share capital is set at eight million four hundred twenty-one thousand three hundred fifty-three
United States Dollars and eighty-one Cents of United States Dollar (USD 8,421,353.81) consisting of the following shares:
(a) two hundred fifty-two million six hundred thirty-nine thousand six hundred sixty-seven (252,639,667) Class A1
shares having a nominal value of one Cent of an United States Dollar (USD 0.01) per share;
(b) two hundred fifty-two million six hundred thirty-nine thousand six hundred sixty-seven (252,639,667) Class A2
shares having a nominal value of one Cent of an United States Dollar (USD 0.01) per share;
(c) two hundred fifty-two million six hundred thirty-nine thousand six hundred sixty-six (252,639,666) Class A3 shares
having a nominal value of one Cent of an United States Dollar (USD 0.01) per share;
(d) eighteen million seven hundred fourteen thousand four hundred seventy-nine (18,714,479) Class B1 shares having
a nominal value of one Cent of an United States Dollar (USD 0.01) per share;
(e) eighteen million seven hundred fourteen thousand four hundred seventy-nine (18,714,479) Class B2 shares having
a nominal value of one Cent of an United States Dollar (USD 0.01) per share;
(f) eighteen million seven hundred fourteen thousand four hundred seventy-nine (18,714,479) Class B3 shares having
a nominal value of one Cent of an United States Dollar (USD 0.01) per share;
(g) nine million three hundred fifty-seven thousand six hundred forty-eight (9,357,648) Class C1 shares having a nominal
value of one Cent of an United States Dollar (USD 0.01) per share;
(h) nine million three hundred fifty-seven thousand six hundred forty-eight (9,357,648) Class C2 shares having a nominal
value of one Cent of an United States Dollar (USD 0.01) per share;
(i) nine million three hundred fifty-seven thousand six hundred forty-eight (9,357,648) Class C3 shares having a nominal
value of one Cent of an United States Dollar (USD 0.01) per share;
95985
L
U X E M B O U R G
<i>Estimation of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in any form whatsoever, which are to be borne by the Company or which shall
be charged to it in connection with the present deed, have been estimated at about EUR 2,000.-.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation. On express request of the same appearing
persons, and in case any divergences would arise between the French and the English text, the English text will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, known to the notary by surname, name and residence, said
persons signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille quatorze, le quatorze avril.
Par devant Maître Henri Hellinckx, notaire, de résidence à Luxembourg,
A comparu:
1) Tahoe Cayman Ltd., une limited liability company constituée et régie par les lois des Iles Caymans, ayant son siège
social à bâtiment Ugland House, KY-KY1-1104 Grand Cayman, Iles Caïmans, inscrite au Registrar of Companies of the
Cayman Islands sous le numéro 265063 («Cayco»),
ici représentée par Louis Servagean-Hilst, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration
donnée en date du 14 avril 2014.
2) Misys Manco S.C.A., une société en commandite par actions, constituée et régie par les lois du Grand-Duché de
Luxembourg, ayant son siège social au 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 166514 (“Manco”),
ici représentée par Louis Servagean-Hilst, prénommé, en vertu d'une procuration donnée en date du 14 avril 2014.
Les procurations, signées "ne varietur" par les comparants et par le notaire soussigné, resteront annexées au présent
acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Les comparants sont les associés (les «Associés») de Misys Newco S.à r.l., une société à responsabilité limitée, con-
stituée et régie par les lois du Grand-Duché du Luxembourg, ayant un capital social d’un montant de huit millions trois
cent quatre-vingt-sept mille huit cent soixante-dix-sept dollars américains et vingt-trois cents (USD 8.387.877,23), ayant
son siège social au 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 167479, constituée suivant acte reçu par Maître Martine
Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, le 13 mars 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
du 22 mars 2012 numéro 755 (ci-après la «Société»). Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte
notarié de Maître Henri Hellinckx du 27 mars 2013 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 14 juin
2014 numéro 1419.
Les Associés ont alors revu l’ordre du jour suivant (l’«Ordre du Jour»):
<i>Ordre du jouri>
1. Augmentation du capital social de la Société par un montant de trente-trois mille quatre cent soixante-seize dollars
américains et cinquante-huit cents (USD 33.476,58) afin de le porter de son montant actuel de huit millions trois cent
quatre-vingt-sept mille huit cent soixante-dix-sept dollars américains et vingt-trois cents (USD 8.387.877,23) à un nouveau
montant de huit millions quatre cent vingt-et-un mille trois cent cinquante-trois dollars américains et quatre-vingt-et-un
cents (USD 8.421.353,81) par l’émission de (i) sept cent quarante-trois mille huit cent quatre-vingt-six (743.886) parts
sociales de catégorie B1 de la Société ayant une valeur nominale d’un cent de dollar américain (USD 0,01) chacune, (ii)
sept cent quarante-trois mille huit cent quatre-vingt-six (743.886) parts sociales de catégorie B2 de la Société ayant une
valeur nominale d’un cent de dollar américain (USD 0,01) chacune, (iii) sept cent quarante-trois mille huit cent quatre-
vingt-six (743.886) parts sociales de catégorie B3 de la Société ayant une valeur nominale d’un cent de dollar américain
(USD 0,01) chacune, (iv) trois cent soixante-douze mille (372.000) parts sociales de catégorie C1 de la Société ayant une
valeur nominale d’un cent de dollar américain (USD 0,01) chacune; (v) trois cent soixante-douze mille (372.000) parts
sociales de catégorie C2 de la Société ayant une valeur nominale d’un cent de dollar américain (USD 0,01) chacune et
(vi) trois cent soixante-douze mille (372.000) parts sociales de catégorie C3 de la Société ayant une valeur nominale d’un
cent de dollar américain (USD 0,01) chacune, et
2. Modification subséquente de l’article 5.1 des statuts de la Société.
Les comparants, représentant l’intégralité du capital social de la Société, ont demandé au notaire de prendre acte des
résolutions suivantes:
<i>Première résolution:i>
Les Associés décident d’augmenter capital social de la Société par un montant de de trente-trois mille quatre cent
soixante-seize dollars américains et cinquante-huit cents (USD 33.476,58) afin de le porter de son montant actuel de huit
95986
L
U X E M B O U R G
millions trois cent quatre-vingt-sept mille huit cent soixante-dix-sept dollars américains et vingt-trois cents (USD
8.387.877,23) à un nouveau montant de huit millions quatre cent vingt-et-un mille trois cent cinquante-trois dollars
américains et quatre-vingt-et-un cents (USD 8.421.353,81) par l’émission de (i) sept cent quarante-trois mille huit cent
quatre-vingt-six (743.886) parts sociales de catégorie B1 de la Société ayant une valeur nominale d’un cent de dollar
américain (USD 0,01) chacune, (ii) sept cent quarante-trois mille huit cent quatre-vingt-six (743.886) parts sociales de
catégorie B2 de la Société ayant une valeur nominale d’un cent de dollar américain (USD 0,01) chacune, (iii) sept cent
quarante-trois mille huit cent quatre-vingt-six (743.886) parts sociales de catégorie B3 de la Société ayant une valeur
nominale d’un cent de dollar américain (USD 0,01) chacune, (iv) trois cent soixante-douze mille (372.000) parts sociales
de catégorie C1 de la Société ayant une valeur nominale d’un cent de dollar américain (USD 0,01) chacune, (v) trois cent
soixante-douze mille (372.000) parts sociales de catégorie C2 de la Société ayant une valeur nominale d’un cent de dollar
américain (USD 0,01) chacune, et (vi) trois cent soixante-douze mille (372.000) parts sociales de catégorie C3 de la Société
ayant une valeur nominale d’un cent de dollar américain (USD 0,01) chacune.
La totalité des (i) sept cent quarante-trois mille huit cent quatre-vingt-six (743.886) nouvelles parts sociales de catégorie
B1, (ii) sept cent quarante-trois mille huit cent quatre-vingt-six (743.886) nouvelles parts sociales de catégorie B2, (iii)
sept cent quarante-trois mille huit cent quatre-vingt-six (743.886) nouvelles parts sociales de catégorie B3, (iv) trois cent
soixante-douze mille (372.000) nouvelles parts sociales de catégorie C1, (v) trois cent soixante-douze mille (372.000)
nouvelles parts sociales de catégorie C2 et (vi) trois cent soixante-douze mille (372.000) nouvelles parts de catégorie C3
ont été entièrement souscrites et intégralement libérées par Manco, prédésignée, ici représentée comme il est dit, en
espèces, de sorte que le montant de trente-trois mille quatre cent soixante-seize dollars américains et cinquante-huit
cents (USD 33.476,58) est dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentant.
<i>Deuxième résolution:i>
Dans le prolongement de la résolution précédente, les Associés décident de modifier l’article 5.1 des Statuts de la
Société de la façon suivante:
“ 5.1. La Société a un capital social huit millions quatre cent vingt-et-un mille trois cent cinquante-trois dollars américains
et quatre-vingt-et-un cents (USD 8.421.353,81) composé de la manière qui suit:
(a) deux cent cinquante-deux millions six cent trente-neuf mille six cent soixante-sept (252.639.667) parts sociales de
catégorie A1 ayant une valeur nominale d’un cent de dollar américain (USD 0,01) chacune;
(b) deux cent cinquante-deux millions six cent trente-neuf mille six cent soixante-sept (252.639.667) parts sociales de
catégorie A2 ayant une valeur nominale d’un cent de dollar américain (USD 0,01) chacune;
(c) deux cent cinquante-deux millions six cent trente-neuf mille six cent soixante-six (252.639.666) parts sociales de
catégorie A3 ayant une valeur nominale d’un cent de dollar américain (USD 0,01) chacune;
(d) dix-huit millions sept cent quatorze mille quatre cent soixante-dix-neuf dollars américains (USD 18.714.479) parts
sociales de catégorie B1 ayant une valeur nominale d’un cent de dollar américain (USD 0,01) chacune;
(e) dix-huit millions sept cent quatorze mille quatre cent soixante-dix-neuf (18.714.479) parts sociales de catégorie B2
ayant une valeur nominale d’un cent de dollar américain (USD 0,01) chacune;
(f) dix-huit millions sept cent quatorze mille quatre cent soixante-dix-neuf (18.714.479) parts sociales de catégorie B3
ayant une valeur nominale d’un cent de dollar américain (USD 0,01) chacune;
(g) neuf millions trois cent cinquante-sept mille six cent quarante-huit (9.357.648) parts sociales de catégorie C1 ayant
une valeur nominale d’un cent de dollar américain (USD 0,01) chacune;
(h) neuf millions trois cent cinquante-sept mille six cent quarante-huit (9.357.648) parts sociales de catégorie C2 ayant
une valeur nominale d’un cent de dollar américain (USD 0,01) chacune;
(i) neuf millions trois cent cinquante-sept mille six cent quarante-huit (9.357.648) parts sociales de catégorie C3 ayant
une valeur nominale d’un cent de dollar américain (USD 0,01) chacune;
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, s'élève à environ EUR 2.000,-.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est
rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction en français. Sur demande expresse du même comparant et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, à la date indiquée au début de ce document.
L'acte ayant été lu au représentant du comparant, connu du notaire par ses prénom, nom et résidence, le représentant
a signé avec Nous, le notaire, le présent acte.
Signé: L. SERVAJEAN-HILST et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 22 avril 2014. Relation: LAC/2014/18653. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
95987
L
U X E M B O U R G
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 26 mai 2014.
Référence de publication: 2014074900/211.
(140087761) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2014.
Goodman Peppermint Logistics (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 164.554.
In the year two thousand and fourteen, on the fifteenth day of the month of May;
Before the undersigned notary Carlo WERSANDT, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg);
THERE APPEARED:
1) The private limited liability company incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg
“GELF Investments (Lux) S.à r.l.”, with registered office in L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches, registered
with the Luxembourg Trade and Companies Register section B under the number 117053; and
2) The private limited liability company incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg
“Goodman Meadow Logistics (Lux) S.à r.l.”, with registered office in L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register section B under the number 176972.
Both are here represented by Mr. Alvin SICRE, employee, residing professionally L-1160 Luxembourg, 28, boulevard
d'Avranches, (the “Proxy-holder”), by virtue of two proxies given under private seal, such proxies, after having been
signed “ne varietur” by the Proxy-holder and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to
be recorded with it.
Such appearing parties, represented as mentioned above, have requested the undersigned notary to enact the following:
- The private limited liability company incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg
“Goodman Peppermint Logistics (Lux) S.à r.l.”, with registered office in L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register section B under the number 164554, (the “Company”),
has been incorporated pursuant to a by a deed of the notary Jean-Joseph WAGNER, residing in Sanem (Grand Duchy of
Luxembourg), on November 8, 2011, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 3140
of December 21, 2011,
and the articles of association (the “Articles”) have not been amended since;
- The appearing parties are the sole actual members of the Company (the “Members”) and they have taken, through
their Proxy-holder, the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Members decide to insert in article 7 of the Articles a restriction in the framework of transfer of shares and to
subsequently amend the second paragraph of the said article as follows:
“In case of plurality of Shareholders, the share(s) held by each Shareholder cannot be transferred without the consent
of all the other Shareholders and by application of the requirements of article 190 of the Law (the “Share Transfer
Approval”).”
<i>Second resolutioni>
The Members decide to insert a new article 8 in the Articles and to give it the following wording:
“ Art. 8. Tag-Along and Drag-Along Rights. The provisions of this Article 8 will apply in the event that, following the
Share Transfer Approval provided for in article 7, the Majority Shareholder (referred to as the “Selling Party” for the
purpose of this article 8) wishes to Transfer all or part of its Shares to a third party (the “Offered Shares”).
In case of the implementation of the Tag-Along Right or the Drag-Along Right, each party transferring Shares shall
bear its respective part of expenses and fees of counsel (including financial, legal and accounting advisors) relating to the
Transfer of the Shares and incurred in relation to the Transfer.
8.1 Transfer Notice
In the event that following the Share Transfer Approval, the Selling Party wishes to Transfer all or part of its Shares
to a third party (the “Purchaser”), the Selling Party shall send to the Minority Shareholder (referred to as the “Non-Selling
Party” for the purpose of this article 8) a notice (the “Transfer Notice”) setting out:
(a) the detailed identity of the Purchaser;
(b) the main terms and conditions of the proposed Transfer, including the price, terms of payment, representations,
warranties and indemnities; and
(c) as the case may be and if applicable, the Selling Party's intention to exercise its Drag-Along Right.
8.2 Tag-Along Right
95988
L
U X E M B O U R G
The Non-Selling Party shall have the right to Transfer, along with the Selling Party, under the same terms and conditions
(in particular with respect to the price, terms of payment, representations, warranties and indemnities) as offered by the
Purchaser to the Selling Party, a maximum number of Shares representing the same proportion of the Shares held by the
Non-Selling Party as the proportion that the Offered Shares bear to the total number of Shares held by the Selling Party
(the “Tag-Along Right”).
The Non-Selling Party may exercise its Tag-Along Right by way of a notice to the Selling Party within twenty (20)
Business Days of receipt of the Transfer Notice (the “Tag-Along Notice”). The Tag-Along Notice will specify the number
of Shares that the Non-Selling Party wishes to Transfer in the context of its Tag-Along Right.
If the Non-Selling Party fails to submit a Tag-Along Notice during the above mentioned period, it will be deemed to
have declined to exercise its Tag-Along Right.
In the event the Non-Selling Party exercises its Tag-Along Right, the Selling Party may only Transfer the Shares referred
to in the Transfer Notice to the Purchaser provided that a number of Shares as referred to in the Tag-Along Notice are
acquired simultaneously by the Purchaser under the same terms and conditions.
8.3 Drag Along Right
If the Selling Party intends to Transfer all (and not part) of its Shares to the Purchaser, the Selling Party may require
the Non-Selling Party, in the Transfer Notice, to Transfer to the Purchaser all (but not less than all) of the Shares held
by the Non-Selling Party at the same price, on the same terms and conditions as, and simultaneously with the purchase
of the Offered Shares (the “Drag-Along Right”).”
<i>Third resolutioni>
The Members also decide to create a new chapter, called “Definitions” and to place said chapter at the end of the
Articles.
The said chapter will henceforth have the following wording:
“Chapter VIII. - Definitions
“Drag Along Right” shall have the meaning set forth in article 8.3;
“Majority Shareholder” means “GELF Investments (Lux) S.à r.l.”, a private limited liability company incorporated and
existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office in L-1160 Luxembourg, 28, boulevard
d'Avranches, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register section B under the number 117053, with
a corporate capital of 1,000,000.- €;
“Minority Shareholder” means “Goodman Meadow Logistics (Lux) S.à r.l.”, a private limited liability company incor-
porated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office in L-1160 Luxembourg,
28, boulevard d'Avranches, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register section B under the number
176972, with a corporate capital of 12,500.- €;
“Non-Selling Party(ies)” shall have the meaning set forth in article 8.1;
“Offered Shares” shall have the meaning set forth in article 8;
“Purchaser” shall have the meaning set forth in article 8.1;
“Selling Party” shall have the meaning set forth in article 8.1;
“Tag-Along Notice” shall have the meaning set forth in article 8.2;
“Tag-Along Right” shall have the meaning set forth in article 8.2.”
<i>Fourth resolutioni>
The Members declare that as a result of inserting a new article 8, the current articles 8 to 17 will be renumbered into
articles 9 to 18.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand and twenty Euros
(EUR 1,020.-).
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that, on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English followed by a German version; on request of the same appearing parties,
and in case of discrepancies between the English and the German text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this docu-
ment.
The deed having been read to the Proxy-holder of the appearing parties, acting as said before, known to the notary
by his first and last name, civil status and residence, the said Proxy-holder has signed with Us, the notary, the present
original deed.
95989
L
U X E M B O U R G
Es folgt die deutsche Fassung des vorstehenden Textes:
Im Jahr zweitausenddreizehn, am fünfzehnten Tag des Monats Mai;
Vor dem unterzeichneten Notar Carlo WERSANDT, mit Amtswohnsitz in Luxemburg, (Großherzogtum Luxemburg);
SIND ERSCHIENEN:
1) Die nach den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg gegründete und bestehende Gesellschaft mit beschränkter
Haftung „GELF Investments (Lux) S.à r.l.“, mit Sitz in L-1160 Luxemburg, 28, Boulevard d'Avranches, eingetragen in
Handels-und Firmenregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 117053; und
2) Die nach den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg gegründete und bestehende Gesellschaft mit beschränkter
Haftung „Goodman Meadow Logistics (Lux) S.à r.l.“, mit Sitz in L-1160 Luxemburg, 28, Boulevard d'Avranches, eingetragen
in Handels- und Firmenregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 176972.
Beide sind hier vertreten durch Herrn Alvin SICRE, Angestellter, beruflich wohnhaft in L-1160 Luxemburg, 28, Bou-
levard d'Avranches, (der „Bevollmächtigte“), auf Grund von zwei ihm erteilten Vollmacht unter Privatschrift, welche
Vollmachten vom Bevollmächtigten und dem amtierenden Notar “ne varietur” unterschrieben, bleiben der gegenwärtigen
Urkunde beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden.
Welche erschienenen Parteien, vertreten wie hiervor erwähnt, den unterzeichneten Notar ersuchen folgendes zu
beurkunden:
- Die nach den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg gegründete und bestehende Gesellschaft mit beschränkter
Haftung „Goodman Peppermint Logistics (Lux) S.à r.l.“, mit Sitz in L-1160 Luxemburg, 28, Boulevard d'Avranches, ein-
getragen in Handels- und Firmenregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 164554, (die “Gesellschaft”), ist
gegründet worden gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Jean-Joseph WAGNER, mit dem Amtssitz in Sassenheim
(Großherzogtum Luxemburg), am 8. November 2011, veröffentlicht im Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
Nummer 3140 vom 21. Dezember 2011,
und die Statuten (die „Statuten“) sind seitdem nicht mehr abgeändert worden;
- Die erschienenen Parteien sind die derzeitigen alleinigen Gesellschafter der Gesellschaft (die „Gesellschafter“) und
sie haben durch ihren Bevollmächtigten, folgende Beschlüsse genommen:
<i>Erster Beschlussi>
Die Gesellschafter beschließen in Artikel 7 der Statuten eine Einschränkung im Rahmen der Übertragung von Ge-
schäftsanteilen einzufügen und dementsprechend den zweiten Absatz besagten Artikels abzuändern wie folgt:
„Im Falle mehrerer Gesellschafter, dürfen die von jedem einzelnen Gesellschafter gehaltenen Gesellschaftsanteile nicht
ohne die Zustimmung aller anderen Gesellschafter und unter Anwendung der Bedingungen von Artikel 190 des Gesetztes,
abgetreten werden („Genehmigung für die Übertragung von Geschäftsanteilen“).“
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Gesellschafter beschließen einen neuen Artikel 8 in die Statuten einzuführen und ihm folgenden Wortlaut zu geben:
„ Art. 8. Mitveräußerungsrechte und -Pflichten. Die in diesem Artikel 8 vorgesehenen Regelungen kommen zur An-
wendung, wenn der Mehrheitsgesellschafter (für die Zwecke dieses Artikels 8 „veräußernder Vertragspartner“ genannt)
nach der Genehmigung für die Übertragung von Geschäftsanteilen gemäß Artikel 7 alle oder einige seiner Geschäftsanteile
auf einen Dritten übertragen möchte (die „angebotenen Geschäftsanteile“).
Im Falle der Wahrnehmung eines Mitveräußerungsrechts bzw. einer Mitveräußerungspflicht wird jeder Vertragspart-
ner, der Geschäftsanteile überträgt, die Ausgaben und Honorare, die ihm in Zusammenhang mit der Übertragung der
Geschäftsanteile für Berater (einschließlich Finanz-, Rechts und Wirtschaftsprüfungsberater) entstehen, selbst tragen.
8.1 Übertragungsmitteilung
Wenn der veräußernde Vertragspartner nach Ausstellung einer Genehmigung für die Übertragung von Geschäftsan-
teilen alle oder einige seiner Geschäftsanteile auf einen Dritten („Käufer“) übertragen möchte, wird er dem Minderheits-
gesellschafter (für die Zwecke dieses Artikels 8 „nicht veräußernder Vertragspartner“ genannt) eine Mitteilung zukommen
lassen, in der:
(a) nähere Angaben zur Identität des Käufers;
(b) die wichtigsten Bedingungen und Konditionen der vorgesehenen Übertragung, einschließlich Preis, Zahlungsmo-
dalitäten, Zusicherungen, Gewährleistungen und Freistellungen; und
(c) gegebenenfalls die Absicht des veräußernden Vertragspartners auf Einforderung der Mitveräußerungspflichten;
aufgeführt sind.
8.2 Mitveräußerungsrecht
Der nicht veräußernde Vertragspartner hat das Recht, die höchstmögliche Anzahl seiner Geschäftsanteile, die zu den
von ihm insgesamt gehaltenen Anteilen das gleiche Verhältnis aufweisen wie die angebotenen Geschäftsanteile zu der
Gesamtanzahl der von dem veräußernden Vertragspartner gehalten Anteile, zusammen mit der von dem veräußernden
Vertragspartner vorgenommenen Übertragung unter den gleichen Bedingungen und Konditionen (in Bezug auf Preis,
95990
L
U X E M B O U R G
Zahlungsmodalitäten, Zusicherungen, Gewährleistungen und Freistellungen) ebenfalls zu übertragen („Mitveräußerungs-
recht“).
Der nicht veräußernde Vertragspartner kann sein Mitveräußerungsrecht anhand einer Nachricht an den veräußernden
Vertragspartner innerhalb von zwanzig (20) Geschäftstagen nach Erhalt der Übertragungsmitteilung wahrnehmen (die
„Mitveräußerungsnachricht“). In dieser Mitveräußerungsnachricht ist die Anzahl der Geschäftsanteile zu benennen, die
der nicht veräußernde Vertragspartner bei der Wahrnehmung seines Mitveräußerungsrechts übertragen möchte.
Legt der nicht veräußernde Vertragspartner innerhalb der vorerwähnten Frist keine Mitveräußerungsnachricht vor,
gilt, dass er sein Mitveräußerungsrecht nicht wahrzunehmen wünscht.
Nimmt der nicht veräußernde Vertragspartner sein Mitveräußerungsrecht wahr, darf der veräußernde Vertragspartner
nur die in der Übertragungsmitteilung genannten Geschäftsanteile auf den Käufer übertragen, vorausgesetzt, die in der
Mitveräußerungsnachricht genannte Anzahl an Geschäftsanteilen wird von dem Käufer unter den gleichen Bedingungen
und Konditionen gleichzeitig erworben.
8.3 Mitveräußerungspflicht
Sofern der veräußernde Vertragspartner alle (und nicht nur einige) seiner Geschäftsanteile auf den Käufer übertragen
möchte, ist er berechtigt, den nicht veräußernden Vertragspartner in der Übertragungsmitteilung aufzufordern, sämtliche
(und in keinem Fall nur einige) von dem nicht veräußernden Vertragspartner gehaltenen Geschäftsanteile zum gleichen
Preis und zu gleichen Bedingungen und Konditionen zusammen mit dem Kauf der angebotenen Geschäftsanteile auf den
Käufer zu übertragen („Mitveräußerungspflicht“).“
<i>Dritter Beschlussi>
Die Gesellschafter beschließen ein neues Kapitel, genannt „Definitionen“ zu schaffen und besagtes Kapitel am Ende
der Statuten einzubringen.
Besagtes Kapitel wird fortan folgenden Wortlaut erhalten:
„Kapitel VIII. Definitionen
„Mitveräußerungspflicht“ hat die diesem Begriff in Artikel 8.3 zugewiesene Bedeutung;
„Mehrheitsgesellschafter“ bedeutet die „GELF Investments (Lux) S.à r.l.“, eine nach den Gesetzen des Großherzogtums
Luxemburg gegründete und bestehende Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Sitz in L-1160 Luxemburg, 28, Bou-
levard d'Avranches, eingetragen in Handels- und Firmenregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 117053,
mit einem Gesellschaftskapital von 1.000.000,- €;
„Minderheitsgesellschafter“ bedeutet die „Goodman Meadow Logistics (Lux) S.à r.l.“, eine nach den Gesetzen des
Großherzogtums Luxemburg gegründete und bestehende Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Sitz in L-1160 Lu-
xemburg, 28, Boulevard d'Avranches, eingetragen in Handels- und Firmenregister von Luxemburg, Sektion B, unter der
Nummer 176972, mit einem Gesellschaftskapital von 12.500,- €;
„Nicht veräußernde(r) Vertragspartner“ hat die diesem Begriff in Artikel 8.1 zugewiesene Bedeutung;
„Angebotene Geschäftsanteile“ hat die diesem Begriff in Artikel 8 zugewiesene Bedeutung;
„Käufer“ hat die diesem Begriff in Artikel 8.1 zugewiesene Bedeutung;
„Veräußernder Vertragspartner“ hat die diesem Begriff in Artikel 8.1 zugewiesene Bedeutung;
„Mitveräußerungsnachricht“ hat die diesem Begriff in Artikel 8.2 zugewiesene Bedeutung;
„Mitveräußerungsrecht“ hat die diesem Begriff in Artikel 8.2 zugewiesene Bedeutung.“
<i>Vierter Beschlussi>
Die Gesellschafterin erklären, dass infolge des Einfügens eines neuen Artikels 8, die aktuellen Artikel 8 bis 17 in Artikel
9 bis 18 um-nummeriert werde.
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr tausendzwanzig Euro
(1.020,-EUR).
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnende Notar, die die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit, dass, auf Wunsch der oben ge-
nannten erschienen Parteien, die vorliegende Urkunde in englischer Sprache verfasste wurde, gefolgt von einer deutschen
Fassung; gemäß dem Wunsch derselben Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und deutschen
Text, ist die englische Fassung maßgebend.
WORÜBER die vorliegende notarielle Urkunde in Luxemburg, an dem oben angegebenen Tag, erstellt wurde.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten der erschienenen Parteien, namens handelnd wie
hiervor erwähnt, dem amtierenden Notar nach Vor- und Zunamen, Personenstand und Wohnort bekannt, hat derselbe
Bevollmächtigte mit Uns, dem Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
95991
L
U X E M B O U R G
Signé: A. SICRE, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 20 mai 2014. LAC/2014/23230. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société;
Luxembourg, le 26 mai 2014.
Référence de publication: 2014074702/221.
(140087996) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2014.
GSLP I Onshore S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 138.795.
In the year two thousand and fourteen, on the fifteenth day of May,
Before Maître Carlo WERSANDT, notary public residing in Luxembourg, undersigned.
Is held
an extraordinary general meeting of the shareholder of GSLP I Onshore S.à r.l., a société à responsabilité limitée duly
incorporated and validly existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2, rue
du Fossé, L-1536 Luxembourg, with a share capital of EUR 12,500 and registered with the Luxembourg Registre de
Commerce et des Sociétés (Trade and Companies Register) under number B 138.795 (the “Company”).
THERE APPEARED:
GSLP I Onshore Investment Fund, L.L.C., a corporation organized and existing under the laws of Delaware, duly
registered with the Department of State, Division of Corporations of Delaware under number 4546633, having its re-
gistered office at Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, 19801 Wilmington, Delaware, United States of America;
(the “Shareholder”),
here represented by Mrs Marielle STIJGER, private employee, having her professional address in Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal, such proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy-holder
and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.
Said appearing party, represented as mentioned above, requested the undersigned notary to draw up the following:
<i>Agendai>
The amendment of the first and second paragraph of article 10 of the articles of incorporation of the Company, in
order to cancel the minimum number of managers as well as to cancel the managers' classes (A and B).
After this had been set forth, the Shareholder, representing the entire capital of the Company, now requests the
undersigned notary to record the following resolution:
<i>Sole resolutioni>
The Shareholder decides to amend the first and second paragraphs of article 10 of the articles of incorporation of the
Company, in order to cancel the minimum number of managers as well as to cancel the managers' classes (A and B). The
article 10 of the articles of incorporation of the Company henceforth shall read as follows:
“Title III. - Management
Art. 10. The company is managed by one or several managers, who need not be shareholders.
In case of plurality of managers, the managers shall form a board of managers being the corporate body in charge of
the Company's management and representation. To the extend applicable and where the term “sole manager” is not
expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of
association shall be read as a reference to the “sole manager”.”
There being no further business, the meeting is closed.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French translation. On request of the same appearing party
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF, this deed was drawn up in Luxembourg, on the date set at the beginning of this deed.
This deed having been read to the proxyholder of the appearing party, who is known to the notary by her first and
surname, civil status and residence, said proxyholder signed together with the notary the present deed.
95992
L
U X E M B O U R G
Suit la traduction en français du texte qui précède
L'an deux mille quatorze, le quinzième jour du mois de mai.
Par-devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
Se réunit
une assemblée générale extraordinaire de l'associé de la société GSLP I Onshore S.à r.l., une société à responsabilité
limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social à 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg, avec un capital social de 12,500 EUR, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 138.795 (la «Société»).
A COMPARU:
GSLP I Onshore Investment Fund, L.L.C., une société constituée et opérant sous le droit de l'Etat de Delaware,
enregistrée auprès du Department of State, Division of Corporations de Delaware sous le numéro 4546633, ayant son
siège social au Trust Center, 1209 Orange Street, 19801 Wilmington, Delaware, Etats-Unis d'Amérique;
(l'«Associé»),
ici représentée par Madame Marielle STIJGER, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle procuration, après avoir été signée “ne varietur” par
la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui;
Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a demandé au notaire soussigné d'acter ce qui suit:
<i>Ordre du jouri>
La modification du premier et du deuxième paragraphe de l'article 10 des articles de constitution de la Société, afin
de supprimer le nombre minimum de gérants de la Société et de supprimer les classes de gérants (A et B).
Ceci ayant été exposé, l'Associé, représentant l'intégralité du capital de la Société, requiert désormais le notaire
instrumentaire de prendre acte de la décision suivante.
<i>Résolution uniquei>
L'Associé décide de modifier le premier et le deuxième paragraphe de l'article 10 des statuts de la Société afin de
supprimer le nombre minimum de gérants de la Société et de supprimer les classes de gérants (A et B). L'article 10 des
Articles des statuts de la Société aura désormais la teneur suivante:
“Titre III. - Administration
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.
En cas de pluralité de gérants, les gérants constituent un conseil de gérance, étant l'organe chargé de la gérance et de
la représentation de la société. Dans la mesure où le terme «gérant unique» n'est pas expressément mentionné dans les
présents statuts, une référence au «conseil de gérance» utilisée dans les présents statuts doit être lue comme une réfé-
rence au «gérant unique».”
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur demande de la partie comparante, le présent acte
est rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la demande de la même partie comparante et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête du présent.
L'acte ayant été lu à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire par ses noms, prénoms usuels, état civil
et demeure, celle-ci a signé avec le notaire, le présent acte.
Signé: M. STIJGER, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 20 mai 2014. LAC/2014/23231. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société;
Luxembourg, le 26 mai 2014.
Référence de publication: 2014074744/91.
(140088113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2014.
95993
L
U X E M B O U R G
Gapi Europe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 61.924.
DISSOLUTION
L'an deux mille quatorze,
le seize mai.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg),
a comparu:
Monsieur Pierandrea AMEDEO, administrateur de société, demeurant au 67, avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de:
«GAPI SpA», une société par actions simplifiée constituée et existant sous le droit italien, établie et ayant son siège
social à I-24060 Castelli Calepio, Via Molinaretti, 2 (Italie), (le «mandant»),
en vertu d'une procuration sous seing privé lui donnée à Luxembourg, le 30 avril 2014,
laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et le notaire
instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Lequel mandataire, ès-dites qualités qu'il agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses
déclarations et constatations:
1.- Que la société «GAPI EUROPE S.A.» (la «Société»), une société anonyme, inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 61 924, établie et ayant son siège social au 60, Grand-Rue,
L-1660 Luxembourg, fut constituée suivant acte notarié dressé en date du 21 novembre 1997, lequel acte fut publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») le 07 mars 1999, sous le numéro 143 et page 6830 et
dont les statuts furent modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié dressé par le notaire soussigné en date du 19
décembre 2013, publié au Mémorial, le 20 février 2014, sous le numéro 471 et page 22576;
2.- Que le capital social de la Société s'élève actuellement à SIX CENT VINGT-CINQ MILLE EUROS (625'000.- EUR)
divisé en vingt-cinq mille (25'000) actions ordinaires d'une valeur nominale de VINGT-CINQ EUROS (25.- EUR) chacune,
toutes se trouvant intégralement libérées en numéraire;
3.- Que son mandant est devenu propriétaire de la totalité des vingt-cinq mille (25'000) actions ordinaires de la Société
«GAPI EUROPE S.A.»;
4.- qu'en tant qu'actionnaire unique son mandant déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite Société,
avec effet immédiat;
5.- Que son mandant, agissant tant en sa qualité de liquidateur de la Société, qu'en qualité d'actionnaire unique de cette
même Société, déclare en outre que l'activité de la Société a cessé, qu'il est investi de tout l'actif, que le passif connu de
ladite Société a été réglé ou provisionné et qu'il s'engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éven-
tuellement encore exister à charge de la Société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne;
partant la liquidation de la Société «GAPI EUROPE S.A.», est à considérer comme faite et clôturée;
6.- Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs actuels et au commissaire aux comptes de la
Société présentement dissoute;
7.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq (5) ans à l'ancien siège social de
la Société dissoute;
8.- Que le mandant s'engage à régler personnellement tous les frais des présentes.
Et à l'instant le mandataire de la personne comparante a présenté au notaire instrumentant tous les certificats d'actions
au porteur de la Société éventuellement émis, le cas échéant le livre des actionnaires nominatifs de la Société, lesquels
ont été annulés.
Pour les dépôt et publication à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d'une expédition des présentes.
DONT ACTE, passé à Belvaux, Grand-Duché de Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête des
présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire instrumentant
par nom, prénom usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec Nous notaire instrumentant le présent acte.
Signé: P. AMEDEO, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 20 mai 2014. Relation: EAC/2014/6990. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2014074715/55.
(140087861) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2014.
95994
L
U X E M B O U R G
Goodman Teal Logistics (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 169.412.
In the year two thousand and fourteen, on the fifteenth day of the month of May;
Before the undersigned notary Carlo WERSANDT, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg);
THERE APPEARED:
1) The private limited liability company incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg
“GELF Investments (Lux) S.à r.l.”, with registered office in L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches, registered
with the Luxembourg Trade and Companies Register section B under the number 117053; and
2) The private limited liability company incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg
“Goodman Meadow Logistics (Lux) S.à r.l.”, with registered office in L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register section B under the number 176972.
Both are here represented by Mr. Alvin SICRE, employee, residing professionally L-1160 Luxembourg, 28, boulevard
d’Avranches, (the “Proxy-holder”), by virtue of two proxies given under private seal, such proxies, after having been
signed “ne varietur” by the Proxy-holder and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to
be recorded with it.
Such appearing parties, represented as mentioned above, have requested the undersigned notary to enact the following:
- The private limited liability company incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg
“Goodman Teal Logistics (Lux) S.à r.l.”, with registered office in L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches, regis-
tered with the Luxembourg Trade and Companies Register section B under the number 169412, (the “Company”), has
been incorporated pursuant to a by a deed of the notary Jean-Joseph WAGNER, residing in Sanem (Grand Duchy of
Luxembourg), on June 11, 2012, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1742 of July
11, 2012,
and the articles of association (the “Articles”) have not been amended since;
- The appearing parties are the sole actual members of the Company (the “Members”) and they have taken, through
their Proxy-holder, the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Members decide to insert in article 7 of the Articles a restriction in the framework of transfer of shares and to
subsequently amend the second paragraph of the said article as follows:
“In case of plurality of Shareholders, the share(s) held by each Shareholder cannot be transferred without the consent
of all the other Shareholders and by application of the requirements of article 190 of the Law (the “Share Transfer
Approval”).”
<i>Second resolutioni>
The Members decide to insert a new article 8 in the Articles and to give it the following wording:
“ Art. 8. Tag-Along and Drag-Along Rights. The provisions of this Article 8 will apply in the event that, following the
Share Transfer Approval provided for in article 7, the Majority Shareholder (referred to as the “Selling Party” for the
purpose of this article 8) wishes to Transfer all or part of its Shares to a third party (the “Offered Shares”).
In case of the implementation of the Tag-Along Right or the Drag-Along Right, each party transferring Shares shall
bear its respective part of expenses and fees of counsel (including financial, legal and accounting advisors) relating to the
Transfer of the Shares and incurred in relation to the Transfer.
8.1 Transfer Notice
In the event that following the Share Transfer Approval, the Selling Party wishes to Transfer all or part of its Shares
to a third party (the “Purchaser”), the Selling Party shall send to the Minority Shareholder (referred to as the “Non-Selling
Party” for the purpose of this article 8) a notice (the “Transfer Notice”) setting out:
(a) the detailed identity of the Purchaser;
(b) the main terms and conditions of the proposed Transfer, including the price, terms of payment, representations,
warranties and indemnities; and
(c) as the case may be and if applicable, the Selling Party's intention to exercise its Drag-Along Right.
8.2 Tag-Along Right
The Non-Selling Party shall have the right to Transfer, along with the Selling Party, under the same terms and conditions
(in particular with respect to the price, terms of payment, representations, warranties and indemnities) as offered by the
Purchaser to the Selling Party, a maximum number of Shares representing the same proportion of the Shares held by the
Non-Selling Party as the proportion that the Offered Shares bear to the total number of Shares held by the Selling Party
(the “Tag-Along Right”).
95995
L
U X E M B O U R G
The Non-Selling Party may exercise its Tag-Along Right by way of a notice to the Selling Party within twenty (20)
Business Days of receipt of the Transfer Notice (the “Tag-Along Notice”). The Tag-Along Notice will specify the number
of Shares that the Non-Selling Party wishes to Transfer in the context of its Tag-Along Right.
If the Non-Selling Party fails to submit a Tag-Along Notice during the above mentioned period, it will be deemed to
have declined to exercise its Tag-Along Right.
In the event the Non-Selling Party exercises its Tag-Along Right, the Selling Party may only Transfer the Shares referred
to in the Transfer Notice to the Purchaser provided that a number of Shares as referred to in the Tag-Along Notice are
acquired simultaneously by the Purchaser under the same terms and conditions.
8.3 Drag Along Right
If the Selling Party intends to Transfer all (and not part) of its Shares to the Purchaser, the Selling Party may require
the Non-Selling Party, in the Transfer Notice, to Transfer to the Purchaser all (but not less than all) of the Shares held
by the Non-Selling Party at the same price, on the same terms and conditions as, and simultaneously with the purchase
of the Offered Shares (the “Drag-Along Right”).”
<i>Third resolutioni>
The Members also decide to create a new chapter, called “Definitions” and to place said chapter at the end of the
Articles.
The said chapter will henceforth have the following wording:
“Chapter VIII. - Definitions
“Drag Along Right” shall have the meaning set forth in article 8.3;
“Majority Shareholder” means “GELF Investments (Lux) S.à r.l.”, a private limited liability company incorporated and
existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office in L-1160 Luxembourg, 28, boulevard
d'Avranches, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register section B under the number 117053, with
a corporate capital of 1,000,000.- €;
“Minority Shareholder” means “Goodman Meadow Logistics (Lux) S.à r.l.”, a private limited liability company incor-
porated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office in L-1160 Luxembourg,
28, boulevard d'Avranches, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register section B under the number
176972, with a corporate capital of 12,500.- €;
“Non-Selling Party(ies)” shall have the meaning set forth in article 8.1;
“Offered Shares” shall have the meaning set forth in article 8;
“Purchaser” shall have the meaning set forth in article 8.1;
“Selling Party” shall have the meaning set forth in article 8.1;
“Tag-Along Notice” shall have the meaning set forth in article 8.2;
“Tag-Along Right” shall have the meaning set forth in article 8.2.”
<i>Fourth resolutioni>
The Members declare that as a result of inserting a new article 8, the current articles 8 to 17 will be renumbered into
articles 9 to 18.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand and twenty Euros
(EUR 1,020.-).
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that, on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English followed by a German version; on request of the same appearing parties,
and in case of discrepancies between the English and the German text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this docu-
ment.
The deed having been read to the Proxy-holder of the appearing parties, acting as said before, known to the notary
by his first and last name, civil status and residence, the said Proxy-holder has signed with Us, the notary, the present
original deed.
Es folgt die deutsche Fassung des vorstehenden Textes:
Im Jahr zweitausenddreizehn, am fünfzehnten Tag des Monats Mai;
Vor dem unterzeichneten Notar Carlo WERSANDT, mit Amtswohnsitz in Luxemburg, (Großherzogtum Luxemburg);
95996
L
U X E M B O U R G
SIND ERSCHIENEN:
1) Die nach den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg gegründete und bestehende Gesellschaft mit beschränkter
Haftung „GELF Investments (Lux) S.à r.l.“, mit Sitz in L-1160 Luxemburg, 28, Boulevard d’Avranches, eingetragen in
Handelsund Firmenregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 117053; und
2) Die nach den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg gegründete und bestehende Gesellschaft mit beschränkter
Haftung „Goodman Meadow Logistics (Lux) S.à r.l.“, mit Sitz in L-1160 Luxemburg, 28, Boulevard d’Avranches, eingetragen
in Handels- und Firmenregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 176972.
Beide sind hier vertreten durch Herrn Alvin SICRE, Angestellter, beruflich wohnhaft in L-1160 Luxemburg, 28, Bou-
levard d’Avranches, (der „Bevollmächtigte“), auf Grund von zwei ihm erteilten Vollmacht unter Privatschrift, welche
Vollmachten vom Bevollmächtigten und dem amtierenden Notar “ne varietur” unterschrieben, bleiben der gegenwärtigen
Urkunde beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden.
Welche erschienenen Parteien, vertreten wie hiervor erwähnt, den unterzeichneten Notar ersuchen folgendes zu
beurkunden:
- Die nach den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg gegründete und bestehende Gesellschaft mit beschränkter
Haftung „Goodman Teal Logistics (Lux) S.à r.l.“, mit Sitz in L-1160 Luxemburg, 28, Boulevard d’Avranches, eingetragen
in Handels- und Firmenregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 169412, (die “Gesellschaft”), ist gegründet
worden gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Jean-Joseph WAGNER, mit dem Amtssitz in Sassenheim (Großher-
zogtum Luxemburg), am 11. Juni 2012, veröffentlicht im Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1742
vom 11. Juli 2012,
und die Statuten (die „Statuten“) sind seitdem nicht mehr abgeändert worden;
- Die erschienenen Parteien sind die derzeitigen alleinigen Gesellschafter der Gesellschaft (die „Gesellschafter“) und
sie haben durch ihren Bevollmächtigten, folgende Beschlüsse genommen:
<i>Erster Beschlussi>
Die Gesellschafter beschließen in Artikel 7 der Statuten eine Einschränkung im Rahmen der Übertragung von Ge-
schäftsanteilen einzufügen und dementsprechend den zweiten Absatz besagten Artikels abzuändern wie folgt:
„Im Falle mehrerer Gesellschafter, dürfen die von jedem einzelnen Gesellschafter gehaltenen Gesellschaftsanteile nicht
ohne die Zustimmung aller anderen Gesellschafter und unter Anwendung der Bedingungen von Artikel 190 des Gesetztes,
abgetreten werden („Genehmigung für die Übertragung von Geschäftsanteilen“).“
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Gesellschafter beschließen einen neuen Artikel 8 in die Statuten einzuführen und ihm folgenden Wortlaut zu geben:
„ Art. 8. Mitveräußerungsrechte und -pflichten. Die in diesem Artikel 8 vorgesehenen Regelungen kommen zur An-
wendung, wenn der Mehrheitsgesellschafter (für die Zwecke dieses Artikels 8 „veräußernder Vertragspartner“ genannt)
nach der Genehmigung für die Übertragung von Geschäftsanteilen gemäß Artikel 7 alle oder einige seiner Geschäftsanteile
auf einen Dritten übertragen möchte (die „angebotenen Geschäftsanteile“).
Im Falle der Wahrnehmung eines Mitveräußerungsrechts bzw. einer Mitveräußerungspflicht wird jeder Vertragspart-
ner, der Geschäftsanteile überträgt, die Ausgaben und Honorare, die ihm in Zusammenhang mit der Übertragung der
Geschäftsanteile für Berater (einschließlich Finanz-, Rechts und Wirtschaftsprüfungsberater) entstehen, selbst tragen.
8.1 Übertragungsmitteilung
Wenn der veräußernde Vertragspartner nach Ausstellung einer Genehmigung für die Übertragung von Geschäftsan-
teilen alle oder einige seiner Geschäftsanteile auf einen Dritten („Käufer“) übertragen möchte, wird er dem Minderheits-
gesellschafter (für die Zwecke dieses Artikels 8 „nicht veräußernder Vertragspartner“ genannt) eine Mitteilung zukommen
lassen, in der:
(a) nähere Angaben zur Identität des Käufers;
(b) die wichtigsten Bedingungen und Konditionen der vorgesehenen Übertragung, einschließlich Preis, Zahlungsmo-
dalitäten, Zusicherungen, Gewährleistungen und Freistellungen; und
(c) gegebenenfalls die Absicht des veräußernden Vertragspartners auf Einforderung der Mitveräußerungspflichten;
aufgeführt sind.
8.2 Mitveräußerungsrecht
Der nicht veräußernde Vertragspartner hat das Recht, die höchstmögliche Anzahl seiner Geschäftsanteile, die zu den
von ihm insgesamt gehaltenen Anteilen das gleiche Verhältnis aufweisen wie die angebotenen Geschäftsanteile zu der
Gesamtanzahl der von dem veräußernden Vertragspartner gehalten Anteile, zusammen mit der von dem veräußernden
Vertragspartner vorgenommenen Übertragung unter den gleichen Bedingungen und Konditionen (in Bezug auf Preis,
Zahlungsmodalitäten, Zusicherungen, Gewährleistungen und Freistellungen) ebenfalls zu übertragen („Mitveräußerungs-
recht“).
Der nicht veräußernde Vertragspartner kann sein Mitveräußerungsrecht anhand einer Nachricht an den veräußernden
Vertragspartner innerhalb von zwanzig (20) Geschäftstagen nach Erhalt der Übertragungsmitteilung wahrnehmen (die
95997
L
U X E M B O U R G
„Mitveräußerungsnachricht“). In dieser Mitveräußerungsnachricht ist die Anzahl der Geschäftsanteile zu benennen, die
der nicht veräußernde Vertragspartner bei der Wahrnehmung seines Mitveräußerungsrechts übertragen möchte.
Legt der nicht veräußernde Vertragspartner innerhalb der vorerwähnten Frist keine Mitveräußerungsnachricht vor,
gilt, dass er sein Mitveräußerungsrecht nicht wahrzunehmen wünscht.
Nimmt der nicht veräußernde Vertragspartner sein Mitveräußerungsrecht wahr, darf der veräußernde Vertragspartner
nur die in der Übertragungsmitteilung genannten Geschäftsanteile auf den Käufer übertragen, vorausgesetzt, die in der
Mitveräußerungsnachricht genannte Anzahl an Geschäftsanteilen wird von dem Käufer unter den gleichen Bedingungen
und Konditionen gleichzeitig erworben.
8.3 Mitveräußerungspflicht
Sofern der veräußernde Vertragspartner alle (und nicht nur einige) seiner Geschäftsanteile auf den Käufer übertragen
möchte, ist er berechtigt, den nicht veräußernden Vertragspartner in der Übertragungsmitteilung aufzufordern, sämtliche
(und in keinem Fall nur einige) von dem nicht veräußernden Vertragspartner gehaltenen Geschäftsanteile zum gleichen
Preis und zu gleichen Bedingungen und Konditionen zusammen mit dem Kauf der angebotenen Geschäftsanteile auf den
Käufer zu übertragen („Mitveräußerungspflicht“).“
<i>Dritter Beschlussi>
Die Gesellschafter beschließen ein neues Kapitel, genannt „Definitionen“ zu schaffen und besagtes Kapitel am Ende
der Statuten einzubringen.
Besagtes Kapitel wird fortan folgenden Wortlaut erhalten:
„Kapitel VIII. Definitionen
„Mitveräußerungspflicht“ hat die diesem Begriff in Artikel 8.3 zugewiesene Bedeutung;
„Mehrheitsgesellschafter“ bedeutet die „GELF Investments (Lux) S.à r.l.“, eine nach den Gesetzen des Großherzogtums
Luxemburg gegründete und bestehende Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Sitz in L-1160 Luxemburg, 28, Bou-
levard d’Avranches, eingetragen in Handels- und Firmenregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 117053,
mit einem Gesellschaftskapital von 1.000.000,- €;
„Minderheitsgesellschafter“ bedeutet die „Goodman Meadow Logistics (Lux) S.à r.l.“, eine nach den Gesetzen des
Großherzogtums Luxemburg gegründete und bestehende Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Sitz in L-1160 Lu-
xemburg, 28, Boulevard d’Avranches, eingetragen in Handels- und Firmenregister von Luxemburg, Sektion B, unter der
Nummer 176972, mit einem Gesellschaftskapital von 12.500,- €;
„Nicht veräußernde(r) Vertragspartner“ hat die diesem Begriff in Artikel 8.1 zugewiesene Bedeutung;
„Angebotene Geschäftsanteile“ hat die diesem Begriff in Artikel 8 zugewiesene Bedeutung;
„Käufer“ hat die diesem Begriff in Artikel 8.1 zugewiesene Bedeutung;
„Veräußernder Vertragspartner“ hat die diesem Begriff in Artikel 8.1 zugewiesene Bedeutung;
„Mitveräußerungsnachricht“ hat die diesem Begriff in Artikel 8.2 zugewiesene Bedeutung;
„Mitveräußerungsrecht“ hat die diesem Begriff in Artikel 8.2 zugewiesene Bedeutung.“
<i>Vierter Beschlussi>
Die Gesellschafterin erklären, dass infolge des Einfügens eines neuen Artikels 8, die aktuellen Artikel 8 bis 17 in Artikel
9 bis 18 um-nummeriert werde.
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr tausendzwanzig Euro
(1.020,-EUR).
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnende Notar, die die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit, dass, auf Wunsch der oben ge-
nannten erschienen Parteien, die vorliegende Urkunde in englischer Sprache verfasste wurde, gefolgt von einer deutschen
Fassung; gemäß dem Wunsch derselben Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und deutschen
Text, ist die englische Fassung maßgebend.
WORÜBER die vorliegende notarielle Urkunde in Luxemburg, an dem oben angegebenen Tag, erstellt wurde.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten der erschienenen Parteien, namens handelnd wie
hiervor erwähnt, dem amtierenden Notar nach Vor- und Zunamen, Personenstand und Wohnort bekannt, hat derselbe
Bevollmächtigte mit Uns, dem Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Signé: A. SICRE, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 20 mai 2014. LAC/2014/23229. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
95998
L
U X E M B O U R G
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société.
Luxembourg, le 26 mai 2014.
Référence de publication: 2014074704/221.
(140087925) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2014.
IK Investment Partners S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 6.906.875,00.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 98.911.
<i>Extrait du contrat de rachat de parts sociales date du 22 mai 2014i>
Il résulte d'un contrat de rachat de parts sociales daté du 22 mai 2014 que la Société a racheté 3,980 de ses propres
parts sociales préférentielles de classe D dans les proportions suivantes:
Cédants
Nombre
de parts
sociales D
détenues
dans la
Société
Christopher Masek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
823
Mads Ryum Larsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
343
James William Yates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
206
MAJA Vermögensverwaltungsgesellschaft GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
823
Stellaris AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
398
International Kapital Investment Partners S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
398
Anders Petersson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
261
Remko Hilhorst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
261
Stanhope Invest S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
261
Cosigrande AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
206
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.980
Par suite du contrat susmentionné, les associés de la Société sont les suivants:
Nom des associés
Nombre de parts sociales détenues
FATBUREN Europa BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.642 parts sociales ordinaires de classe A
IK Investment Partners S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.980 parts sociales préférentielles de classe D
Christopher Masek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
823 parts sociales préférentielles de classe E
823 parts sociales préférentielles de classe F
823 parts sociales préférentielles de classe G
823 parts sociales préférentielles de classe H
823 parts sociales préférentielles de classe I
Mads Ryum Larsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
343 parts sociales préférentielles de classe E
343 parts sociales préférentielles de classe F
343 parts sociales préférentielles de classe G
343 parts sociales préférentielles de classe H
343 parts sociales préférentielles de classe I
James William Yates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
206 parts sociales préférentielles de classe E
206 parts sociales préférentielles de classe F
206 parts sociales préférentielles de classe G
206 parts sociales préférentielles de classe H
206 parts sociales préférentielles de classe I
MAJA Vermögensverwaltungsgesell schaft GmbH . . . . . . . . . . . . . .
823 parts sociales préférentielles de classe E
823 parts sociales préférentielles de classe F
823 parts sociales préférentielles de classe G
823 parts sociales préférentielles de classe H
823 parts sociales préférentielles de classe I
Stellaris AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
398 parts sociales préférentielles de classe E
398 parts sociales préférentielles de classe F
398 parts sociales préférentielles de classe G
95999
L
U X E M B O U R G
398 parts sociales préférentielles de classe H
398 parts sociales préférentielles de classe I
International Kapital Investment Partners S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
398 parts sociales préférentielles de classe E
398 parts sociales préférentielles de classe F
398 parts sociales préférentielles de classe G
398 parts sociales préférentielles de classe H
398 parts sociales préférentielles de classe I
Anders Petersson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
261 parts sociales préférentielles de classe E
261 parts sociales préférentielles de classe F
261 parts sociales préférentielles de classe G
261 parts sociales préférentielles de classe H
261 parts sociales préférentielles de classe I
Remko Hilhorst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
261 parts sociales préférentielles de classe E
261 parts sociales préférentielles de classe F
261 parts sociales préférentielles de classe G
261 parts sociales préférentielles de classe H
261 parts sociales préférentielles de classe I
Stanhope Invest S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
261 parts sociales préférentielles de classe E
261 parts sociales préférentielles de classe F
261 parts sociales préférentielles de classe G
261 parts sociales préférentielles de classe H
261 parts sociales préférentielles de classe I
Cosigrande AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
206 parts sociales préférentielles de classe E
206 parts sociales préférentielles de classe F
206 parts sociales préférentielles de classe G
206 parts sociales préférentielles de classe H
206 parts sociales préférentielles de classe I
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.642 parts sociales ordinaires de classe A;
3.980 parts sociales préférentielles de classe D ;
3.980 parts sociales préférentielles de classe E ;
3.980 parts sociales préférentielles de classe F ;
3.980 parts sociales préférentielles de classe G ;
3.980 parts sociales préférentielles de classe H ;
3.980 parts sociales préférentielles de classe I.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 20014.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2014074778/92.
(140087880) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2014.
Wiltz RCG Re SCA, Société en Commandite par Actions.
Capital social: USD 1.618.001,00.
Siège social: L-4243 Esch-sur-Alzette, 97, rue Jean-Pierre Michels.
R.C.S. Luxembourg B 46.306.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 21 mai 2014i>
L'Assemblée a pris la résolution suivante:
- L'Assemblée décide de nommer comme Réviseur d'entreprises agréé PricewaterhouseCoopers S.à.r.l. ayant son
siège social au 400, route d'Esch, L-1014 Luxembourg. Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire
qui se tiendra en 2015 devant statuer sur les comptes de l'exercice 2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2014074305/16.
(140086359) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
96000
A-Cars S.à.r.l.
Brightstar Holdings & Investments S.A.
Caisse Raiffeisen Mersch
Gapi Europe S.A.
Goodman Flame Logistics (Lux) S.à r.l.
Goodman Harvest Logistics (Lux) S.à r.l.
Goodman Peppermint Logistics (Lux) S.à r.l.
Goodman Teal Logistics (Lux) S.à r.l.
GREYBEX S.à r.l
GSLP I Onshore S.à r.l.
GWE S.A
GWM Holding S.A.
IK Investment Partners S.à r.l.
Invesco Promotions S.à r.l.
Lux-Tours s.à r.l.
Magic Newco S.à r.l.
Mathur
Misys Newco S.à r.l.
Select Equities
Selector Management Fund
Sigma Immobilière S.à r.l.
Simsa S.A.
Sintesi S.C.A.
SL Transports
Smogon S.A.
Société de Développement International et de Capitaux S.A.
Société Hôtelière de la Pétrusse S.A.
Soelan S.A.
SOGEDEC, Société Générale d'Etudes et de Coordination S. à r.l.
Solaia Re S.à r.l.
Southbury Holding S.à r.l.
Southbury Holding S.à r.l.
Sovac 5 S.à r.l.
SPK S.A.
Sport Lux S.à r.l.
SSP Resources Gloucester Parent 2 S.à r.l.
Steda s.à.r.l.
Swiss-Lux Financial Holding S.A.H.
Tanarive Properties S.à r.l.
Taranis International S.A.
Tasman Properties S.à r.l.
Tatiana
Tatra Investments S.à r.l.
Tatra S.à r.l.
Tea Properties S.à.r.l.
Tenencia Properties S.à r.l.
The Kooples Luxembourg S.à r.l.
Tishman Speyer Junghof Holdings S.à r.l.
Tishman Speyer Junghof LP I S.à r.l.
Tishman Speyer Junghof LP S.à r.l.
Tishman Speyer Pacific Holdings S.à r.l.
Tishman Speyer Pacific S.à r.l.
TMC Immo S.à r.l.
TMF Administrative Services S.A.
TMF Administrative Services S.A.
Trafigura Funding S.A.
Trafigura Investments S.à r.l.
Trafigura Trade Investments (Luxembourg) S.à r.l.
Transes International S.A.
Transes Investments S.A.
Transports MAES International S.à r.l.
Turbine Holdings S.à r.l.
Turtle Holdings S.A.
Umwelttechnik-Tankreinigung-Tankanlage-Altoelsammlung & Entsorgung
Uni-Games S.àr.l.
Wiltz RCG Re SCA