logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1984

29 juillet 2014

SOMMAIRE

ASCENSEURS Luxembourg S.A.  . . . . . . . .

95222

BMO Finance Company I  . . . . . . . . . . . . . . .

95223

Coni  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95226

EsDé Immobilier S.C.I.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

95227

Global Sporting Rights Investments S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95229

OCM Luxembourg Coppice Midco S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95196

Roadexpress Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95195

Smat's  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95186

Smat's  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95186

Socafe s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95186

Société Générale Bank & Trust . . . . . . . . . .

95196

Société Générale Bank & Trust . . . . . . . . . .

95186

Sofidecor S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95186

Spaniba S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95230

SPPR S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95232

Street Smart Société Civile  . . . . . . . . . . . . .

95187

Switex S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95230

Sword Group SE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95187

Sword Group SE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95188

Taurus Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

95187

Tele2 Finance Luxembourg S.A. . . . . . . . . .

95187

Telenetwork Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . .

95189

Telenetwork Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . .

95189

Telenetwork Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . .

95189

Tempus Capital One GP S.à r.l.  . . . . . . . . .

95188

Themis Realty Europe  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95190

TIAA Lux 5 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95190

Tishman Speyer Europe S.à r.l.  . . . . . . . . . .

95190

TMC Immo S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95190

TMC Immo S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95191

TMC Immo S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95191

TOP Finanzbeteiligungs S.A.  . . . . . . . . . . . .

95191

Torrent Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

95191

Transports Internationaux Wefa S.à.r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95192

Trasteel Investments Holding S.A. . . . . . . .

95192

Trasteel Investments Holding S.A. . . . . . . .

95192

Trasteel Trading Holding S.A. . . . . . . . . . . .

95193

TR S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95192

Turaz Global S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95188

Turkey Juice Company S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

95188

UBS Fund Management (Luxembourg)

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95193

UBS Fund Management (Luxembourg)

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95194

UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.  . .

95195

UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.  . .

95194

UBS (Lux) Institutional Sicav II  . . . . . . . . . .

95188

UBS (Lux) Institutional Sicav II  . . . . . . . . . .

95232

UBS (Lux) Money Market Sicav  . . . . . . . . .

95230

UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav  . . . . . . . . . .

95193

UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav  . . . . . . . . . .

95231

Uncia S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95195

Urban Capital Lender 1 S.à r.l.  . . . . . . . . . .

95191

Urban Capital Lender 2 S.à r.l.  . . . . . . . . . .

95193

Usine du Nord S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95193

Vallis Construction Sector Consolidation

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95195

Valon S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95189

Vier Gas Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

95231

Vizzion Participations, SCA  . . . . . . . . . . . . .

95192

Weichai Power (Luxembourg) Holding S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95232

Weiss Optik S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95194

95185

L

U X E M B O U R G

Smat's, Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 115.192.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

MAZARS ATO

Référence de publication: 2014073317/10.
(140086243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2014.

Smat's, Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 115.192.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

MAZARS ATO

Référence de publication: 2014073318/10.
(140086244) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2014.

Socafe s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1460 Luxembourg, 8, rue d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 65.563.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014073319/10.
(140085693) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2014.

Sofidecor S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 37.580.

Les comptes annuels au 30 septembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23/05/2014.

Signature.

Référence de publication: 2014073327/10.
(140086108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2014.

Société Générale Bank & Trust, Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 6.061.

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 28 mars 2014

3.4 Renouvellement du mandat de réviseur d'entreprise
Conformément à l'article 26-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et à l'article 12 des statuts de

la SGBT, le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de renouveler pour un an le mandat de la société Deloitte S.A.,
établie à Luxembourg, en qualité de Réviseur d'Entreprise.

Patrick VINCENT
<i>Le Secrétaire du Conseil d'Administration

Référence de publication: 2014073325/14.
(140086156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2014.

95186

L

U X E M B O U R G

Taurus Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 45.000,00.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 56, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 158.900.

Les comptes annuels de la société au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2014073343/12.
(140085990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2014.

Sword Group SE, Société Européenne.

Siège social: L-8009 Strassen, 105, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 168.244.

Les comptes annuels consolidés au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014073340/11.
(140085625) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2014.

Street Smart Société Civile, Société Civile.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg E 4.720.

<i>Extrait des résolutions écrites prises par le conseil de gérance de la société en date du 16 mai 2014

Il résulte des résolutions écrites prises par le Conseil de Gérance de la Société en date du 16 mai 2014 que (traduction

libre):

<i>«Deuxième résolution

Le Conseil de Gérance constate le changement de l'adresse professionnelle de Monsieur Mario DI STEFANO, en tant

que Gérant, membre du Conseil de Gérance et Associé de la Société, du 2a Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, au
55-57, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 mai 2014.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014073336/19.
(140085920) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2014.

Tele2 Finance Luxembourg S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 7, avenue Jean-Pierre Pescatore.

R.C.S. Luxembourg B 112.873.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour TELE2 FINANCE LUXEMBOURG S.A.
Société anonyme
FIDUCIAIRE DES P.M.E. SA

Référence de publication: 2014073344/12.
(140085404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2014.

95187

L

U X E M B O U R G

Sword Group SE, Société Européenne.

Siège social: L-8009 Strassen, 105, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 168.244.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014073341/10.
(140085626) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2014.

Tempus Capital One GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1748 Findel, 7, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 179.259.

Les statuts coordonnés au 23 avril 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Marc Loesch
<i>Notaire

Référence de publication: 2014073345/11.
(140085993) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2014.

Turaz Global S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 164.046.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 68626 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014073352/10.
(140086249) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2014.

Turkey Juice Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 166.393.

Les comptes annuels de la société Turkey Juice Company S.à r.l. au 31/12/2012 ont été déposés au registre de com-

merce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014073353/10.
(140086068) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2014.

UBS (Lux) Institutional Sicav II, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 115.356.

Les comptes annuels au 31 janvier 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour UBS (Lux) Institutional SICAV II
UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Guillaume André / Mathias Welter
<i>Director / Associate Director

Référence de publication: 2014073385/13.
(140085550) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2014.

95188

L

U X E M B O U R G

Telenetwork Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6637 Wasserbillig, 59, Esplanade de la Moselle.

R.C.S. Luxembourg B 129.496.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014073356/9.
(140085792) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2014.

Telenetwork Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6637 Wasserbillig, 59, Esplanade de la Moselle.

R.C.S. Luxembourg B 129.496.

Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014073357/9.
(140085793) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2014.

Telenetwork Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6637 Wasserbillig, 59, Esplanade de la Moselle.

R.C.S. Luxembourg B 129.496.

<i>Protokoll der ordentlichen Hauptversammlung vom 20. Mai 2014

Die Generalversammlung hat beschloßen, die Mandate der Verwaltungsratmitglieder:
Herr Volker Alfred Eisel
Herr Klaus-Peter Schömer
Herr Jean Bernard Zeimet
für weitere 6 Jahre zu verlängern, also bis zur jährlichen Hauptversammlung 2018.
Die Mandate der Delegierten des Vewaltungsrates, Herren Herr Volker Alfred Eisel und Klaus-Peter Schömer, werden

ebenfalls für weitere 6 Jahre verlängert, also bis zur jährlichen Hauptversammlung 2018.

Die Generalversammlung hat Kenntnis von die Adressenänderungen der drei Verwalter genommen:
Herr Volker Alfred Eisel, Poststrasse 7, D-54340 Leiwen
Herr Klaus-Peter Schömer, Am Wissenschaftspark 13, D-54296 Trier
Herr Jean Bernard Zeimet, 3A, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
Référence de publication: 2014073358/19.
(140085816) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2014.

Valon S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 63.143.

Par décision de l'assemblée générale annuelle tenue en date du 21 mai 2014, le mandat des Administrateurs Messieurs

Guy BAUMANN, Jean-Marie BETTINGER et Madame Magali MICHELETTI ainsi que celui du Commissaire aux comptes
AUDIT TRUST S.A., société anonyme, ont été renouvelés pour une durée de six ans, prenant fin à l'issue de l'assemblée
générale annuelle de 2020.

Luxembourg, le 22 mai 2014.

<i>Pour: VALON S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Aurélie Katola / Susana Goncalves Martins

Référence de publication: 2014073405/17.
(140085516) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2014.

95189

L

U X E M B O U R G

Themis Realty Europe, Société Anonyme.

Siège social: L-1836 Luxembourg, 23, rue Jean Jaurès.

R.C.S. Luxembourg B 134.999.

Le bilan abrégé au 31 juillet 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Dandois &amp; Meynial

Référence de publication: 2014073360/10.
(140085768) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2014.

TIAA Lux 5 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 5.654.700,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 115.160.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 mai 2014.

Référence de publication: 2014073361/10.
(140085989) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2014.

Tishman Speyer Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.125.000,00.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 130.284.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique en date du 20 février 2014 que le mandat de la société suivante a

été renouvelé jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui approuvera les comptes au 31 décembre 2014:

- KPMG Luxembourg, société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg,

Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le
numéro B 149133.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 22 mai 2014.

Pour extrait conforme
ATOZ
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Signature

Référence de publication: 2014073362/22.
(140085619) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2014.

TMC Immo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1326 Luxembourg, 7, rue Auguste Charles.

R.C.S. Luxembourg B 156.151.

Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

L-2537 Luxembourg, le 12 mai 2014.

Monsieur Daniel Schweitzer
<i>Gérant technique

Référence de publication: 2014073363/12.
(140085354) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2014.

95190

L

U X E M B O U R G

TMC Immo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1326 Luxembourg, 7, rue Auguste Charles.

R.C.S. Luxembourg B 156.151.

Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

L-2537 Luxembourg, le 12 mai 2014.

Monsieur Daniel Schweitzer
<i>Gérant technique

Référence de publication: 2014073364/12.
(140085399) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2014.

TMC Immo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1326 Luxembourg, 7, rue Auguste Charles.

R.C.S. Luxembourg B 156.151.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

L-2537 Luxembourg, le 12 mai 2014.

Monsieur Daniel Schweitzer
<i>Gérant technique

Référence de publication: 2014073365/12.
(140085439) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2014.

TOP Finanzbeteiligungs S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4940 Bascharage, 240, avenue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 61.721.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014073367/10.
(140086159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2014.

Torrent Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 85.057.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014073369/10.
(140085757) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2014.

Urban Capital Lender 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 179.132.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 68627 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014073381/10.
(140085679) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2014.

95191

L

U X E M B O U R G

TR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1456 Luxembourg, 86-88, rue de l'Egalité.

R.C.S. Luxembourg B 62.436.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014073370/9.
(140085471) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2014.

Transports Internationaux Wefa S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9053 Ettelbruck, 45, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 14.953.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinter-

legt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Unterschrift.

Référence de publication: 2014073373/11.
(140086160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2014.

Trasteel Investments Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 147.158.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014073374/9.
(140085459) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2014.

Trasteel Investments Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 147.158.

Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014073375/9.
(140085460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2014.

Vizzion Participations, SCA, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 139.316.

Il convient de noter que le liquidateur SGG-FFW S.A, avec siège social au 412F, route d'Esch L-1471 Luxembourg

B67.905 a été absorbée lors de sa fusion en date du 22 novembre 2011 avec la société SGG S.A..

Dorénavant le liquidateur se dénomme de la façon suivante:
SGG S.A., sise 412F, route d'Esch L-2086 Luxembourg enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Lu-

xembourg sous le numéro B 65.906.

Fait à Luxembourg, le 23 mai 2014.

Certifié conforme et sincère
<i>POUR VIZZION PARTICIPATIONS S.C.A
Signature

Référence de publication: 2014073402/16.
(140085783) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2014.

95192

L

U X E M B O U R G

Trasteel Trading Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 147.155.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014073376/9.
(140085461) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2014.

Urban Capital Lender 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 179.135.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 68628 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014073383/10.
(140085736) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2014.

Usine du Nord S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 169.671.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014073384/9.
(140086073) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2014.

UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 99.462.

Les comptes annuels au 31 octobre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV
UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Guillaume André / Mathias Welter
<i>Director / Associate Director

Référence de publication: 2014073388/13.
(140085546) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2014.

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 154.210.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Guillaume André / Mathias Welter
<i>Director / Associate Director

Référence de publication: 2014073392/13.
(140085556) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2014.

95193

L

U X E M B O U R G

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 154.210.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale annuelle du 30 avril 2014:

Sont réélus au conseil d'administration pour une période se terminant à l'assemblée générale annuelle de 2015:
- M. Andreas Schlatter, Président du conseil d'administration, Stockerstrasse 64, CH-8002 Zürich, Suisse.
- M. Mario Cueni, Membre du conseil d'administration, Stockerstrasse 64, CH-8002 Zurich, Suisse.
- M. Christian Eibel, Membre du conseil d'administration, Stockerstrasse 64, CH-8002 Zürich, Suisse.
- M. Gilbert Schintgen, Membre du conseil d'administration, 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg.
- M. Martin Thommen, Membre du conseil d'administration, Aeschenplatz 6, CH-4052 Bâle, Suisse.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Guillaume André / Mathias Welter
<i>Director / Associate Director

Référence de publication: 2014073393/19.
(140085557) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2014.

UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 58.535.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale annuelle du 30 avril 2014

- Sont réélus au Conseil d'Administration pour une période se terminant à l'assemblée générale annuelle de 2015:
* M. Mark Porter, président et membre du conseil d'administration, 21 Lombard Street EC3V 9 AH London, Royaume-

Uni.

* M. Markus Krämer, membre du conseil d'administration, 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
* M. Pierre-Antoine Boulat, membre du conseil d'administration, 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
* M. René Mottas, membre du conseil d'administration, 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Guillaume André / Mathias Welter
<i>Director / Associate Director

Référence de publication: 2014073395/18.
(140085553) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2014.

Weiss Optik S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 274, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 161.708.

EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société anonyme
“ WEISS OPTIK S.A. «
tenue l'an deux mille quatorze (2014), le 20 mai, à 11h,
à son siège social à Luxembourg, que les actionnaires ont décidé:
de transférer le siège social de:
26 Boulevard Grande Duchesse Charlotte L-1330-Luxembourg
à
274 avenue Gaston Diderich L-1420-Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014073429/17.
(140085457) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2014.

95194

L

U X E M B O U R G

Uncia S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 176.095.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014073396/9.
(140086229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2014.

UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 58.535.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Guillaume André / Mathias Welter
<i>Director / Associate Director

Référence de publication: 2014073394/12.
(140085552) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2014.

Vallis Construction Sector Consolidation, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 169.301.

Le siège social de l'associé unique Vallis Consolidation Strategies I, S.A. a changé et se trouve désormais au 36, Avenida

da Boavista, Piso I, 4050-112 Porto, Portugal.

L’adresse professionnelle des gérants Luis Ferreira De Magalhaes Santos Carvalho et Pedro Manuel De Almeida Gon-

çalves a changé et se trouve désormais au 36, Avenida da Boavista, Piso I, 4050-112 Porto, Portugal.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 mai 2014.

Référence de publication: 2014073399/14.
(140085533) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2014.

Roadexpress Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5351 Oetrange, 2A, rue du Chemin de Fer.

R.C.S. Luxembourg B 65.561.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait

Par jugement rendu en date du 30 janvier 2014, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Sixième Chambre,

siégeant en matière commerciale, après avoir entendu Madame le Juge Commissaire en son rapport oral, le liquidateur
et le Ministère Public en ses conclusions, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société
suivante:

La société à responsabilité limitée ROADEXPRESS SARL, ayant eu son siège social à: L-5351 OETRANGE, 2A, rue du

chemin de fer, immatriculée au registre du commerce et des société de Luxembourg sous le numéro R.C.S. B 65561;

Ce même jugement a mis les frais à la charge du trésor.

Pour extrait conforme
Maître Philippe GODEBERT
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2014073495/19.
(140085871) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2014.

95195

L

U X E M B O U R G

Société Générale Bank &amp; Trust, Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 6.061.

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration en date du 02 mai 2014

<i>Première résolution:

Conformément à l'article 7 des statuts de la Banque, le Conseil d'Administration décide de renouveler Monsieur Patrick

SUET, demeurant professionnellement, 17 Cours Valmy 92987 Paris-La-Défense, dans ses fonctions de Président du
Conseil d'Administration de Société Générale Bank &amp; Trust, pour une durée d'une année, jusqu'à la prochaine assemblée
générale statutaire prévue pour se tenir le jeudi 07 mai 2015.

<i>Deuxième résolution:

Conformément à l'article 7 des statuts de la Banque, le Conseil d'Administration décide de renouveler Monsieur Jean-

François MAZAUD, demeurant professionnellement, 17 Cours Valmy 92987 Paris-La-Défense, dans ses fonctions de Vice
Président du Conseil d'Administration de Société Générale Bank &amp; Trust, pour une durée d'une année, jusqu'à la prochaine
assemblée générale statutaire prévue pour se tenir le jeudi 07 mai 2015,

<i>Troisième résolution (suite point 4 de l'ordre du jour)

Conformément à l'article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et à l'article 10 des statuts de la

Banque, le Conseil d'Administration décide de renouveler Madame Véronique DE LA BACHELERIE, demeurant profes-
sionnellement, 11 avenue Emile Reuter L-2420 Luxembourg, dans ses fonctions de Déléguée à la gestion journalière, pour
une durée d'une année, jusqu'à la prochaine assemblée générale statutaire prévue pour se tenir le jeudi 07 mai 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19/05/2014.

Patrick Vincent
<i>Secrétaire du Conseil d'Administration

Référence de publication: 2014073324/27.
(140086156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2014.

OCM Luxembourg Coppice Midco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 43.645,13.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 175.318.

In the year two thousand and fourteen, on the third day of February;
Before Us Maître Francis KESSELER, notary residing in Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg;

was held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of OCM Luxembourg Coppice Midco S.à r.l., a

Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 26A, Bou-
levard Royal, L-2449 Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under
number B 175318, incorporated on February 5, 2013 pursuant to a deed of the undersigned notary, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 891, page 42745 on 15 April 2013 (the Company). The articles
of association of the Company (the Articles) have been amended for the last time on February 3, 2014 pursuant to a deed
of the undersigned notary, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

THERE APPEARED:

1. OCM Luxembourg Coppice Topco S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité

limitée), having its registered office at 26A, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg and registered with the Luxembourg
Register of Commerce and Companies under number B 175303 (Topco), here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA
CHAO CONDE, private employee, residing professionally in Esch/Alzette, by virtue of a proxy given under private seal;

2.  Graham  Stewart  Cherry,  company  director,  born  on  15  June  1959,  residing  at  Fridays,  Fox  Road,  Mashbury,

Chelmsford, Essex CM1 4TJ, United Kingdom (Graham Cherry), here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO
CONDE, private employee, residing professionally in Esch/Alzette, by virtue of a proxy given under private seal;

3. Richard Stephen Cherry, company director, born on 20 March 1961, residing at the Old Vicarage, High Street,

Stebbing, Dunmow, Essex CM6 3SF, United Kingdom (Richard Cherry), here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA
CHAO CONDE, private employee, residing professionally in Esch/Alzette, by virtue of a proxy given under private seal;

95196

L

U X E M B O U R G

4. Wendy Elizabeth Colgrave, company director, born on 13 January 1965, residing at Ellis Farm, High Easter, Chelms-

ford, Essex CM1 4RB, United Kingdom (Wendy Colgrave), here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE,
private employee, residing professionally in Esch/Alzette, by virtue of a proxy given under private seal;

5. The Trustees of The Alan Cherry Copthorn Will Trust, an English trust, c/o Speechly Bircham LLP, 6 New Street

Square, London EC4A 3LX, United Kingdom (the Trust), here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE,
private employee, residing professionally in Esch/Alzette, by virtue of a proxy given under private seal;

6. Andrew Carrington, Director, born on 18 February 1975 in Edinburgh, United Kingdom, residing at 68 Avondale

Avenue, Esher, Surrey, KT10 0DA, United Kingdom(Andrew Carrington), here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA
CHAO CONDE, private employee, residing professionally in Esch/Alzette, by virtue of a proxy given under private seal;

7. Angela Hyams Dowding, Group Chief Solicitor, born on 24 June 1963 in Romford, United Kingdom, residing at 69

Roth Drive Hutton, Brentwood, Essex, CM13 2UE, United Kingdom (Angela Hyams Dowding), here represented by Mrs
Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally in Esch/Alzette, by virtue of a proxy given
under private seal;

8. Antony Travers, Managing Director, born on 18 March 1960 in Manchester, United Kingdom, residing at 39 St

Thomas Road, Brentwood, Essex, CM14 4DF, United Kingdom (Antony Travers), here represented by Mrs Sofia AFON-
SO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally in Esch/Alzette, by virtue of a proxy given under private
seal;

9. Christopher Bladon, Director, born on 16 March 1977 in Rochford, United Kingdom, residing at 9 Poplars Avenue,

Hockley, Essex, SS5 4NA, United Kingdom (Christopher Bladon), here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO
CONDE, private employee, residing professionally in Esch/Alzette, by virtue of a proxy given under private seal;

10. David Everett, Managing Director, born on 14 September 1957 in Bishop Auckland, United Kingdom, residing at

Somerville House, 1 Hereward Mount, Stock, Ingatestone, Essex, CM4 9PS, United Kingdom (David Everett), here re-
presented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally in Esch/Alzette, by virtue
of a proxy given under private seal;

11. Ian Kelley, Managing Director, born on 17 October 1961 in Wigan, United Kingdom, residing at 5 Fenwick Close,

Westhoughton, Bolton, Lancashire, BL5 2GQ, United Kingdom (Ian Kelley), here represented by Mrs Sofia AFONSO-
DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally in Esch/Alzette, by virtue of a proxy given under private
seal;

12. James Dodd, Director, born on 19 April 1967 in Romford, United Kingdom, residing at "The Hoppit", The Village,

Great Waltham, Chelmsford, Essex, CM3 1AR, United Kingdom (James Dodd), here represented by Mrs Sofia AFONSO-
DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally in Esch/Alzette, by virtue of a proxy given under private
seal;

13. Richard Reeves, Director, born on 31 December 1962 in Grays, United Kingdom, residing at "The Willows",

Church Lane, Hutton, Brentwood, Essex, CM13 1SB, United Kingdom (Richard Reeves), here represented by Mrs Sofia
AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally in Esch/Alzette, by virtue of a proxy given under
private seal;

14. Michael Hill, Director, born on 20 August 1952 in Redruth, United Kingdom, residing at 12 Rowanwood Avenue,

Sidcup, Kent DA15 8WN, United Kingdom (Michael Hill), here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE,
private employee, residing professionally in Esch/Alzette, by virtue of a proxy given under private seal; and

15. Ian Sutcliffe, Executive Chairman, born on 24 July 1959 in Liverpool, United Kingdom residing at Windlesham

Lodge, Westwood Road, Windlesham, Surrey GU20 6LX, here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE,
private employee, residing professionally in Esch/Alzette, by virtue of a proxy given under private seal;

16. SPEECHLY BIRCHAM NOMINEE COMPANY LIMITED, a company incorporated and registered in England and

Wales with company number 01287713 and whose registered office is at 6 New Street Square, London EC4A 3LX, United
Kingdom, here represented by Mrs Sofia AFONSODA CHAO CONDE, private employee, residing professionally in Esch/
Alzette, by virtue of a proxy given under private seal;

17. David Simpson, managing director, born on March 28, 1955 in Airdie, United Kingdom, residing at Magnolia House,

Vicarage Lane, Hound Green, Hook, Hampshire, RG27 8JJ, United Kingdom, here represented by Mrs Sofia AFONSO-
DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally in Esch/Alzette, by virtue of a proxy given under private
seal; and

18. Nicholas Jackson, land &amp; planning director, born on March 22, 1954, in Derby, United Kingdom, residing at 6

Harvest Place, School Hill, Wargrave, Berkshire, RG10 8AQ, United Kingdom, here represented by Mrs Sofia AFONSO-
DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally in Esch/Alzette, by virtue of a proxy given under private
seal.

The said proxies, after having been signed "ne varietur" by the proxyholders of the appearing parties and the under-

signed notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The Shareholders, prenamed and represented as stated above, representing the entire share capital of the Company,

have requested the undersigned notary to record that:

95197

L

U X E M B O U R G

I. The Company’s share capital is presently set at forty-three thousand two hundred and sixteen British Pounds and

thirty-eight Pence (GBP 43,216.38) represented by (i) one hundred and thirty thousand and two hundred (130,200) class
A1 ordinary shares, (ii) one hundred and thirty thousand and two hundred (130,200) class A2 ordinary shares, (iii) one
hundred and thirty thousand and two hundred (130,200) class A3 ordinary shares, (iv) one hundred and thirty thousand
and two hundred (130,200) class A4 ordinary shares, (v) one hundred and thirty thousand and two hundred (130,200)
class A5 ordinary shares, (vi) twenty-five thousand six hundred and eighty-two (25,682) class AA1 ordinary shares, (vii)
twenty-five  thousand  six  hundred  and  eighty-two  (25,682)  class  AA2  ordinary  shares,  (viii)  twenty-five  thousand  six
hundred and eighty-two (25,682) class AA3 ordinary shares, (ix) twenty-five thousand six hundred and eighty-two (25,682)
class AA4 ordinary shares, (x) twenty-five thousand six hundred and eighty-three (25,683) class AA5 ordinary shares, (xi)
nine thousand ninety-five (9,095) Class B1 ordinary shares, (xii) nine thousand ninety-five (9,095) class B2 ordinary shares,
(xiii) nine thousand ninety-five (9,095) class B3 ordinary shares, (xiv) nine thousand ninety-six (9,096) class B4 ordinary
shares, (xv) nine thousand ninety-six (9,096) class B5 ordinary shares, (xvi) four hundred (400) Class BB1 ordinary shares,
(xvii) four hundred (400) class BB2 ordinary shares, (xviii) four hundred (400) class BB3 ordinary shares, (xix) four hundred
(400) class BB4 ordinary shares, (xx) four hundred (400) class BB5 ordinary shares, (xxi) six hundred and eighty thousand
five hundred and ninety-four (680,594) class C ordinary shares, (xxii) one (1) class D ordinary share, (xxiii) two million
and seventy-four thousand and forty-nine (2,074,049) OCM mandatory redeemable preferred shares, (xxiv) one hundred
and ninety-four thousand six hundred and ninety-one (194,691) CHY mandatory redeemable preferred shares, (xxv) zero
(0) MGT mandatory redeemable preferred shares, and (xxvi) five hundred forty-five thousand four hundred sixty-five
(545,465) FEI mandatory redeemable preferred shares, all in registered form, with a nominal value of one penny (GBP
0.01) each, all subscribed and fully paid-up.

II. The agenda of the meeting is as follows:
1. Waiver of convening notices;
2. Increase of the share capital of the Company by an amount of four hundred and twenty-eight Pound Sterling seventy-

five Pence (GBP 428.75) by way of a subscription in cash and by way of subscription in kind consisting in shares and loan
notes, and subsequently to raise the share capital from its present amount of forty-three thousand two hundred and
sixteen Pound Sterling and thirty-eight Pence (GBP 43,216.38), to forty-three thousand six hundred and forty-five Pound
Sterling thirteen Pence (GBP 43,645.13) by way of the issuance of (i) one thousand four hundred and seventeen (1,417)
class AA1 ordinary shares, (ii) one thousand four hundred and seventeen (1,417) class AA2 ordinary shares, (iii) one
thousand four hundred and seventeen (1,417) class AA3 ordinary shares, (iv) one thousand four hundred and seventeen
(1,417) class AA4 ordinary shares, (v) one thousand four hundred and seventeen (1,417) class AA5 ordinary shares, (vi)
nine hundred (900) Class BB1 ordinary shares, (xii) nine hundred (900) class BB2 ordinary shares, (xiii) nine hundred
(900) class BB3 ordinary shares, (ix) nine hundred (900) class BB4 ordinary shares, (x) nine hundred (900) class BB5
ordinary shares and (xi) thirty-one thousand two hundred and ninety (31,290) MGT mandatory redeemable preferred
shares, all in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each;

3. Subscription to and payment of the share capital increase specified in item 2. above and payment of a share premium;
4. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the share capital increase specified

in items 2. above, with power and authority given to any manager of the Company, each acting individually, to proceed
on behalf of the Company with the newly issued shares, in the register of shareholders of the Company;

5. Subsequent amendment to article 5.1. of the articles of association of the Company;
6. Appointment of an auditor (commissaire aux comptes) of the Company; and
7. Miscellaneous.
III. The Meeting has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The entirety of the share capital of the Company being represented, the Meeting waives the convening notices, the

Shareholders considering themselves as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda which has
been communicated to them in advance.

<i>Second resolution

The Meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of four hundred and twenty-eight

Pound Sterling seventy-five Pence (GBP 428.75) by way of a subscription in cash and by way of subscription in kind
consisting in shares and loan notes, and subsequently to raise the share capital from its present amount of forty-three
thousand two hundred and sixteen Pound Sterling and thirty-eight Pence (GBP 43,216.38), to forty-three thousand six
hundred and forty-five Pound Sterling thirteen Pence (GBP 43,645.13) by way of the issuance of (i) one thousand four
hundred and seventeen (1,417) class AA1 ordinary shares, (ii) one thousand four hundred and seventeen (1,417) class
AA2 ordinary shares, (iii) one thousand four hundred and seventeen (1,417) class AA3 ordinary shares, (iv) one thousand
four hundred and seventeen (1,417) class AA4 ordinary shares, (v) one thousand four hundred and seventeen (1,417)
class AA5 ordinary shares, (vi) nine hundred (900) Class BB1 ordinary shares, (xii) nine hundred (900) class BB2 ordinary
shares, (xiii) nine hundred (900) class BB3 ordinary shares, (ix) nine hundred (900) class BB4 ordinary shares, (x) nine
hundred (900) class BB5 ordinary shares and (xi) thirty-one thousand two hundred and ninety (31,290) MGT mandatory

95198

L

U X E M B O U R G

redeemable preferred shares, all in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each, and having the
rights and obligations attached to them as set forth in the articles of association of the Company.

<i>Third resolution

The Meeting accepts and records the following subscriptions for and full payment of the share capital increase above

as follows:

<i>Subscription - Payment

1. David Simpson, prenamed and represented as stated above, here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO

CONDE, private employee, residing professionally in Esch/Alzette,, by virtue of a proxy given under private seal, declares
to subscribe to:

- five hundred and sixteen (516) AA1 Shares in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each,
five hundred and sixteen (516) AA2 Shares in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each;
five hundred and fifteen (515) AA3 Shares in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each;
five hundred and fifteen (515) AA4 Shares in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each; and
five hundred and fifteen (515) AA5 Shares in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each;
and to pay them up by way of a contribution in kind consisting of one thousand eight hundred and thirty-six (1,836)

shares of OCM Magnum Holdings S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée),
having its registered office at 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, in the process of being registered with the
Luxembourg Register of Commerce and Companies (Magnum), having a par value of three thousand two hundred and
ninety Pound Sterling and sixty-five Pence (GBP 3,290.65) (the Contributed Shares 1), which shall be allocated as follows:

* an amount of twenty-five Pound Sterling and seventy-seven Pence (GBP 25.77) shall be allocated to the nominal share

capital account of the Company; and

* an amount of three thousand two hundred and sixty-four Pound Sterling and eighty-eight Pence (GBP 3,264.88) shall

be allocated to the share premium reserve account of the Company connected to the AA Shares.

It was evidenced by a certificate issued by the Company (the Certificate 1) that:
“David Simpson is the legal and beneficial owner of the Contributed Shares 1;
as of the date of the certificate, the par value of the Contributed Shares 1 is of three thousand two hundred and ninety

Pound Sterling and sixty-five Pence (GBP 3,290.65); and

the Contributed Shares 1 are contributed by David Simpson to the Company in exchange for the issue by the Company

of five hundred and sixteen (516) AA1 Shares, five hundred and sixteen (516) AA2 Shares, five hundred and fifteen (515)
AA3 Shares, five hundred and fifteen (515) AA4 Shares and five hundred and fifteen (515) AA5 Shares, all in registered
form, having a nominal value of one penny (GBP 0.01) each.”

- eleven thousand three hundred and seventy-eight (11,378) MGT MPRS in registered form, with a nominal value of

one penny (GBP 0.01) each, and to fully pay them up by way of a contribution in kind consisting of one million one hundred
and seventy-four thousand seven hundred and sixty-two (1,174,762) preferred equity certificates having a nominal value
of one Pound Sterling (GBP 1) each issued by Magnum, having an aggregate par value of one million one hundred and
seventy-four thousand seven hundred and sixty-two Pound Sterling and twenty-three Pence (GBP 1,174,762.23) (the
Contributed PECs 1), which shall be allocated as follows:

* an amount of one hundred and thirteen Pound Sterling and seventy-eight pence (GBP 113.78) shall be allocated to

the nominal share capital account of the Company;

* an amount of one million one hundred and thirteen thousand and sixty-seven Pound Sterling and ninety-two Pence

(GBP 1,113,076.92) shall be allocated to the share premium reserve account of the Company connected to the MGT
MRPS; and

* an amount of sixty-one thousand five hundred and seventy-one Pound Sterling and fifty-three Pence (GBP 61,571.53)

shall be allocated to the general MRPS share premium reserve account of the Company.

It was evidenced by the Certificate 1 that:
“David Simpson is the legal and beneficial owner of the Contributed PECs 1;
as of the date of the certificate, the par value of the Contributed PECs 1 is of one million one hundred and seventy-

four thousand seven hundred and sixty-two Pound Sterling and twenty-three Pence (1,174,762.23); and

the Contributed PECs 1 are contributed by David Simpson to the Company in exchange for the issue by the Company

of eleven thousand three hundred and seventy-eight (11,378) MGT MPRS, in registered form, having a nominal value of
one penny (GBP 0.01) each.”

2. Paul Beaney, Contruction Director, born on March 12, 1968 in London, United Kingdom, residing at The White

House, Stubbs Hill, Binfield, Berkshire, RG42 5NN, United Kingdom, here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO
CONDE, private employee, residing professionally in Esch/Alzette, by virtue of a proxy given under private seal, declares
to subscribe to:

95199

L

U X E M B O U R G

- three hundred and eighty-six (386) AA1 Shares in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01)

each,

three hundred and eighty-six (386) AA2 Shares in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each;
three hundred and eighty-six (386) AA3 Shares in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each;
three hundred and eighty-seven (387) AA4 Shares in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01)

each; and

three hundred and eighty-seven (387) AA5 Shares in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01)

each;

and to pay them up by way of a contribution in kind consisting of one thousand three hundred and seventy-seven

(1,377) shares of Magnum, having a par value of two thousand four hundred and sixty-seven Pound Sterling and five Pence
(GBP 2,467.05) (the Contributed Shares 2), which shall be allocated as follows:

* an amount of nineteen Pound Sterling and thirty-two Pence (GBP 19.32) shall be allocated to the nominal share

capital account of the Company; and

* an amount of two thousand four hundred and forty-seven Pound Sterling and seventy-three Pence (GBP 2,447.73)

shall be allocated to the share premium reserve account of the Company connected to the AA Shares.

It was evidenced by a certificate issued by the Company (the Certificate 2) that:
“Paul Beaney is the legal and beneficial owner of the Contributed Shares 2;
as of the date of the certificate, the par value of the Contributed Shares 2 is of two thousand four hundred and sixty-

seven Pound Sterling and five Pence (GBP 2,467.05); and

the Contributed Shares 2 are contributed by Paul Beaney to the Company in exchange for the issue by the Company

of three hundred and eighty-six (386) AA1 Shares, three hundred and eighty-six (386) AA2 Shares, three hundred and
eighty-six (386) AA3 Shares, three hundred and eighty-seven (387) AA4 Shares and three hundred and eighty-seven (387)
AA5 Shares, all in registered form, having a nominal value of one penny (GBP 0.01) each.”

- three hundred (300) BB1 Shares, having a nominal value of one penny (GBP 0,01.-) each;
three hundred (300) BB 2 Shares, having a nominal value of one penny (GBP 0,01.-) each;
three hundred (300) BB 3 Shares, having a nominal value of one penny (GBP 0,01.-) each;
three hundred (300) BB 4 Shares, having a nominal value of one penny (GBP 0,01.-) each; and
three hundred (300) BB 5 Shares, having a nominal value of one penny (GBP 0,01.-) each;
and to pay them up by way of a contribution in cash in an aggregate amount of six thousand Pound Sterling (GBP

6,000), which shall be allocated as follows:

* an amount of fifteen Pound Sterling (GBP 15) shall be allocated to the nominal share capital account of the Company;

and

* an amount of five thousand nine hundred and eighty-five Pound Sterling (GBP 5,985) shall be allocated to the share

premium reserve account of the Company connected to the BB Ordinary Shares;

- eight thousand five hundred and thirty (8,530) MGT MPRS in registered form, with a nominal value of one penny

(GBP 0.01) each, and to fully pay them up by way of a contribution in kind consisting of eight hundred and eighty thousand
seven hundred and thirty-seven (880,737) preferred equity certificates having a nominal value of one Pound Sterling (GBP
1) each issued by Magnum, having an aggregate par value of eight hundred and eighty thousand seven hundred and thirty-
seven Pound Sterling and six Pence (GBP 880,737.06) (the Contributed PECs 2), which shall be allocated as follows:

* an amount of eighty-five Pound Sterling and thirty pence (GBP 85.30) shall be allocated to the nominal share capital

account of the Company;

* an amount of eight hundred and thirty-four thousand four hundred and seventy-three Pound Sterling and eleven

Pence (GBP 834,473.11) shall be allocated to the share premium reserve account of the Company connected to the MGT
MRPS; and

* an amount of forty-six thousand one hundred and seventy-eight Pound Sterling and sixty-five Pence (GBP 46,178.65)

shall be allocated to the general MRPS share premium reserve account of the Company.

It was evidenced by the Certificate 2 that:
“Paul Beaney is the legal and beneficial owner of the Contributed PECs 2;
as of the date of the certificate, the par value of the Contributed PECs 2 is of eight hundred and eighty thousand seven

hundred and thirty-seven Pound Sterling and six Pence (GBP 880,737,06); and

the Contributed PECs 2 are contributed by Paul Beaney to the Company in exchange for the issue by the Company

of eight thousand five hundred and thirty (8,530) MGT MPRS, in registered form, having a nominal value of one penny
(GBP 0.01) each.”

3. Jonathan Cranley, Sales and Marketing Director, born on August 31, 1962 in Elstree, United Kingdom, residing at 8

Barber Close, Hurst, Reading, RG10 8JU, United Kingdom, here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE,
private employee, residing professionally in Esch/Alzette, by virtue of a proxy given under private seal, declares to sub-
scribe to:

95200

L

U X E M B O U R G

- one hundred and thirty-one (131) AA1 Shares in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each,
one hundred and thirty (130) AA2 Shares in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each;
one hundred and thirty (130) AA3 Shares in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each;
one hundred and thirty (130) AA4 Shares in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each; and
one hundred and thirty-one (131) AA5 Shares in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each;
and to pay them up by way of a contribution in kind consisting of four hundred and sixty-four (464) shares of Magnum,

having a par value of eight hundred and thirty-two Pound Sterling and sixty-two Pence (GBP 832.62) (the Contributed
Shares 3), which shall be allocated as follows:

* an amount of six Pound Sterling and fifty-two Pence (GBP 6.52) shall be allocated to the nominal share capital account

of the Company; and

* an amount of eight hundred and twenty-six Pound Sterling and ten Pence (GBP 826.10) shall be allocated to the share

premium reserve account of the Company connected to the AA Shares.

It was evidenced by a certificate issued by the Company (the Certificate 3) that:
“Jonathan Cranley is the legal and beneficial owner of the Contributed Shares 3;
as of the date of the certificate, the par value of the Contributed Shares 3 is of eight hundred and thirty-two Pound

Sterling and sixty-two Pence (GBP 832.62); and

the Contributed Shares 3 are contributed by Jonathan Cranley to the Company in exchange for the issue by the

Company of one hundred and thirty-one (131) AA1 Shares, one hundred and thirty (130) AA2 Shares, one hundred and
thirty (130) AA3 Shares, one hundred and thirty (130) AA4 Shares and one hundred and thirty-one (131) AA5 Shares,
all in registered form, having a nominal value of one penny (GBP 0.01) each.”

- one hundred (100) BB1 Shares, having a nominal value of one penny (GBP 0,01.-) each;
one hundred (100) BB 2 Shares, having a nominal value of one penny (GBP 0,01.-) each;
one hundred (100) BB 3 Shares, having a nominal value of one penny (GBP 0,01.-) each;
one hundred (100) BB 4 Shares, having a nominal value of one penny (GBP 0,01.-) each; and
one hundred (100) BB 5 Shares, having a nominal value of one penny (GBP 0,01.-) each;
and to pay them up by way of a contribution in cash in an aggregate amount of two thousand Pound Sterling (GBP

2,000), which shall be allocated as follows:

* an amount of five Pound Sterling (GBP 5) shall be allocated to the nominal share capital account of the Company;

and

* an amount of one thousand nine hundred and ninety-five Pound Sterling (GBP 1,995) shall be allocated to the share

premium reserve account of the Company connected to the BB Ordinary Shares;

- two thousand eight hundred and seventy-nine (2,879) MGT MPRS in registered form, with a nominal value of one

penny (GBP 0.01) each, and to fully pay them up by way of a contribution in kind consisting of two hundred and ninety-
seven thousand two hundred and forty-five (297,245) preferred equity certificates having a nominal value of one Pound
Sterling (GBP 1) each issued by Magnum, having an aggregate par value of two hundred and ninety-seven thousand two
hundred and forty-five Pound Sterling and four Pence (GBP 297,245.04) (the Contributed PECs 3), which shall be allocated
as follows:

* an amount of twenty-eight Pound Sterling and seventy-nine pence (GBP 28.79) shall be allocated to the nominal share

capital account of the Company;

* an amount of two hundred and eighty-one thousand eight hundred and twenty-three Pound Sterling and thirty-seven

Pence (GBP 281,823.37) shall be allocated to the share premium reserve account of the Company connected to the MGT
MRPS; and

* an amount of fifteen thousand three hundred and ninety-two Pound Sterling and eighty-eight Pence (GBP 15,392.88)

shall be allocated to the general MRPS share premium reserve account of the Company.

It was evidenced by the Certificate 3 that:
“Jonathan Cranley is the legal and beneficial owner of the Contributed PECs 3;
as of the date of the certificate, the par value of the Contributed PECs 3 is of two hundred and ninety-seven thousand

two hundred and forty-five Pound Sterling and four Pence (GBP 297,245.04); and

the Contributed PECs 3 are contributed by Jonathan Cranley to the Company in exchange for the issue by the Company

of two thousand eight hundred and seventy-nine (2,879) MGT MPRS, in registered form, having a nominal value of one
penny (GBP 0.01) each.”

4. Paul Wills, Finance Director, born on August 28, 1964 in Redruth, United Kingdom, residing at 12 Drak Lane,

Wargrave, Berkshire, RG10 8JU, United Kingdom, here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private
employee, residing professionally in Esch/Alzette, by virtue of a proxy given under private seal, declares to subscribe to:

- one hundred and thirty-one (131) AA1 Shares in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each,
one hundred and thirty-one (131) AA2 Shares in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each;

95201

L

U X E M B O U R G

one hundred and thirty (130) AA3 Shares in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each;
one hundred and thirty (130) AA4 Shares in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each; and
one hundred and thirty (130) AA5 Shares in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each;
and to pay them up by way of a contribution in kind consisting of four hundred and sixty-four (464) shares of Magnum,

having a par value of eight hundred and thirty-two Pound Sterling and sixty-two Pence (GBP 832.62) (the Contributed
Shares 4), which shall be allocated as follows:

* an amount of six Pound Sterling and fifty-two Pence (GBP 6.52) shall be allocated to the nominal share capital account

of the Company; and

* an amount of eight hundred and twenty-six Pound Sterling and ten Pence (GBP 826.10) shall be allocated to the share

premium reserve account of the Company connected to the AA Shares.

It was evidenced by a certificate issued by the Company (the Certificate 4) that:
“Paul Wills is the legal and beneficial owner of the Contributed Shares 4;
as of the date of the certificate, the par value of the Contributed Shares 4 is of eight hundred and thirty-two Pound

Sterling and sixty-two Pence (GBP 832.62); and

the Contributed Shares 4 are contributed by Paul Wills to the Company in exchange for the issue by the Company of

one hundred and thirty-one (131) AA1 Shares, one hundred and thirty-one (131) AA2 Shares, one hundred and thirty
(130) AA3 Shares, one hundred and thirty (130) AA4 Shares and one hundred and thirty (130) AA5 Shares, all in registered
form, having a nominal value of one penny (GBP 0.01) each.”

- one hundred (100) BB1 Shares, having a nominal value of one penny (GBP 0,01.-) each;
one hundred (100) BB 2 Shares, having a nominal value of one penny (GBP 0,01.-) each;
one hundred (100) BB 3 Shares, having a nominal value of one penny (GBP 0,01.-) each;
one hundred (100) BB 4 Shares, having a nominal value of one penny (GBP 0,01.-) each; and
one hundred (100) BB 5 Shares, having a nominal value of one penny (GBP 0,01.-) each;
and to pay them up by way of a contribution in cash in an aggregate amount of two thousand Pound Sterling (GBP

2,000), which shall be allocated as follows:

* an amount of five Pound Sterling (GBP 5) shall be allocated to the nominal share capital account of the Company;

and

* an amount of one thousand nine hundred and ninety-five Pound Sterling (GBP 1,995) shall be allocated to the share

premium reserve account of the Company connected to the BB Ordinary Shares;

- two thousand eight hundred and seventy-nine (2,879) MGT MPRS in registered form, with a nominal value of one

penny (GBP 0.01) each, and to fully pay them up by way of a contribution in kind consisting of two hundred and ninety-
seven thousand two hundred and forty-five (297,245) preferred equity certificates having a nominal value of one Pound
Sterling (GBP 1) each issued by Magnum, having an aggregate par value of two hundred and ninety-seven thousand two
hundred and forty-five Pound Sterling and four Pence (GBP 297,245.04) (the Contributed PECs 4), which shall be allocated
as follows:

* an amount of twenty-eight Pound Sterling and seventy-nine pence (GBP 28.79) shall be allocated to the nominal share

capital account of the Company;

* an amount of two hundred and eighty-one thousand eight hundred and twenty-three Pound Sterling and thirty-seven

Pence (GBP 281,823.37) shall be allocated to the share premium reserve account of the Company connected to the MGT
MRPS; and

* an amount of fifteen thousand three hundred and ninety-two Pound Sterling and eighty-eight Pence (GBP 15,392.88)

shall be allocated to the general MRPS share premium reserve account of the Company.

It was evidenced by the Certificate 4 that:
“Paul Wills is the legal and beneficial owner of the Contributed PECs 4;
as of the date of the certificate, the par value of the Contributed PECs 4 is of two hundred and ninety-seven thousand

two hundred and forty-five Pound Sterling and four Pence (GBP 297,245.04); and

the Contributed PECs 4 are contributed by Paul Wills to the Company in exchange for the issue by the Company of

two thousand eight hundred and seventy-nine (2,879) MGT MPRS, in registered form, having a nominal value of one penny
(GBP 0.01) each.”

5. Marc Taylor, Commercial Director, born on May 15, 1972 in Hillingdon, United Kingdom, residing at Highwood, 9

Rodney Gardens, Pinner, Middlesex, HA5 2RT, United Kingdom, here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO
CONDE, private employee, residing professionally in Esch/Alzette, by virtue of a proxy given under private seal, declares
to subscribe to:

- one hundred and thirty (130) AA1 Shares in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each,
one hundred and thirty (130) AA2 Shares in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each;
one hundred and thirty-one (131) AA3 Shares in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each;
one hundred and thirty (130) AA4 Shares in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each; and

95202

L

U X E M B O U R G

one hundred and thirty-one (131) AA5 Shares in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each;
and to pay them up by way of a contribution in kind consisting of four hundred and sixty-four (464) shares of Magnum,

having a par value of eight hundred and thirty-two Pound Sterling and sixty-two Pence (GBP 832.62) (the Contributed
Shares 5), which shall be allocated as follows:

* an amount of six Pound Sterling and fifty-two Pence (GBP 6.52) shall be allocated to the nominal share capital account

of the Company; and

* an amount of eight hundred and twenty-six Pound Sterling and ten Pence (GBP 826.10) shall be allocated to the share

premium reserve account of the Company connected to the AA Shares.

It was evidenced by a certificate issued by the Company (the Certificate 5) that:
“Marc Taylor is the legal and beneficial owner of the Contributed Shares 5;
as of the date of the certificate, the par value of the Contributed Shares 5 is of eight hundred and thirty-two Pound

Sterling and sixty-two Pence (GBP 832.62); and

the Contributed Shares 5 are contributed by Marc Taylor to the Company in exchange for the issue by the Company

of one hundred and thirty (130) AA1 Shares, one hundred and thirty (130) AA2 Shares, one hundred and thirty-one (131)
AA3 Shares, one hundred and thirty (130) AA4 Shares and one hundred and thirty-one (131) AA5 Shares, all in registered
form, having a nominal value of one penny (GBP 0.01) each.”

- one hundred (100) BB1 Shares, having a nominal value of one penny (GBP 0,01.-) each;
one hundred (100) BB 2 Shares, having a nominal value of one penny (GBP 0,01.-) each;
one hundred (100) BB 3 Shares, having a nominal value of one penny (GBP 0,01.-) each;
one hundred (100) BB 4 Shares, having a nominal value of one penny (GBP 0,01.-) each; and
one hundred (100) BB 5 Shares, having a nominal value of one penny (GBP 0,01.-) each;
and to pay them up by way of a contribution in cash in an aggregate amount of two thousand Pound Sterling (GBP

2,000), which shall be allocated as follows:

* an amount of five Pound Sterling (GBP 5) shall be allocated to the nominal share capital account of the Company;

and

* an amount of one thousand nine hundred and ninety-five Pound Sterling (GBP 1,995) shall be allocated to the share

premium reserve account of the Company connected to the BB Ordinary Shares;

- two thousand eight hundred and seventy-nine (2,879) MGT MPRS in registered form, with a nominal value of one

penny (GBP 0.01) each, and to fully pay them up by way of a contribution in kind consisting of two hundred and ninety-
seven thousand two hundred and forty-five (297,245) preferred equity certificates having a nominal value of one Pound
Sterling (GBP 1) each issued by Magnum, having an aggregate par value of two hundred and ninety-seven thousand two
hundred and forty-five Pound Sterling and four Pence (GBP 297,245.04) (the Contributed PECs 5), which shall be allocated
as follows:

* an amount of twenty-eight Pound Sterling and seventy-nine pence (GBP 28.79) shall be allocated to the nominal share

capital account of the Company;

* an amount of two hundred and eighty-one thousand eight hundred and twenty-three Pound Sterling and thirty-seven

Pence (GBP 281,823.37) shall be allocated to the share premium reserve account of the Company connected to the MGT
MRPS; and

* an amount of fifteen thousand three hundred and ninety-two Pound Sterling and eighty-eight Pence (GBP 15,392.88)

shall be allocated to the general MRPS share premium reserve account of the Company.

It was evidenced by the Certificate 5 that:
“Marc Taylor is the legal and beneficial owner of the Contributed PECs 5;
as of the date of the certificate, the par value of the Contributed PECs 5 is of two hundred and ninety-seven thousand

two hundred and forty-five Pound Sterling and four Pence (GBP 297,245.04); and

the Contributed PECs 5 are contributed by Marc Taylor to the Company in exchange for the issue by the Company

of two thousand eight hundred and seventy-nine (2,879) MGT MPRS, in registered form, having a nominal value of one
penny (GBP 0.01) each.”

6. Greg Meier, Chief Architect, born on June 2, 1962 in Uffikon, LU, Switzerland, residing at 10 Lewis Close, Harefield,

Uxbridge, Middlesex, UB9 6RD, United Kingdom, here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private
employee, residing professionally in Esch/Alzette, by virtue of a proxy given under private seal, declares to subscribe to:

- fifty-three (53) AA1 Shares in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each,
fifty-three (53) AA2 Shares in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each;
fifty-four (54) AA3 Shares in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each;
fifty-four (54) AA4 Shares in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each; and
fifty-four (54) AA5 Shares in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each;

95203

L

U X E M B O U R G

and to pay them up by way of a contribution in kind consisting of one hundred and ninety-one (191) shares of Magnum,

having a par value of three hundred and forty-two Pound Sterling and sixty-two Pence (GBP 342.62) (the Contributed
Shares 6), which shall be allocated as follows:

* an amount of two Pound Sterling and sixty-eight Pence (GBP 2.68) shall be allocated to the nominal share capital

account of the Company; and

* an amount of three hundred and thirty-nine Pound Sterling and ninety-four Pence (GBP 339.94) shall be allocated to

the share premium reserve account of the Company connected to the AA Shares.

It was evidenced by a certificate issued by the Company (the Certificate 6) that:
“Greg Meier is the legal and beneficial owner of the Contributed Shares 6;
as of the date of the certificate, the par value of the Contributed Shares 6 is of three hundred and forty-two Pound

Sterling and sixty-two Pence (GBP 342.62); and

the Contributed Shares 6 are contributed by Greg Meier to the Company in exchange for the issue by the Company

of fifty-three (53) AA1 Shares, fifty-three (53) AA2 Shares, fifty-four (54) AA3 Shares, fifty-four (54) AA4 Shares and fifty-
four (54) AA5 Shares, all in registered form, having a nominal value of one penny (GBP 0.01) each.”

- one thousand one hundred and eighty-five (1,185) MGT MPRS in registered form, with a nominal value of one penny

(GBP 0.01) each, and to fully pay them up by way of a contribution in kind consisting of one hundred and twenty-two
thousand three hundred and sixteen (122,316) preferred equity certificates having a nominal value of one Pound Sterling
(GBP 1) each issued by Magnum, having an aggregate par value of one hundred and twenty-two thousand three hundred
and sixteen Pound Sterling and thirty-three Pence (GBP 122,316.33) (the Contributed PECs 6), which shall be allocated
as follows:

* an amount of eleven Pound Sterling and eighty-five pence (GBP 11.85) shall be allocated to the nominal share capital

account of the Company;

* an amount of one hundred and fifteen thousand four hundred and sixty-three Pound Sterling and twenty Pence (GBP

115,463.20) shall be allocated to the share premium reserve account of the Company connected to the MGT MRPS; and

* an amount of six thousand eight hundred and forty-one Pound Sterling and twenty-eight Pence (GBP 6,841.28) shall

be allocated to the general MRPS share premium reserve account of the Company.

It was evidenced by the Certificate 6 that:
“Greg Meier is the legal and beneficial owner of the Contributed PECs 6;
as of the date of the certificate, the par value of the Contributed PECs 6 is of one hundred and twenty-two thousand

three hundred and sixteen Pound Sterling and thirty-three Pence (GBP 122,316.33); and

the Contributed PECs 6 are contributed by Greg Meier to the Company in exchange for the issue by the Company

of one thousand one hundred and eighty-five (1,185) MGT MPRS, in registered form, having a nominal value of one penny
(GBP 0.01) each.”

7. David Chandler, Senior Land Manager, born on October 24, 1953 in Kingston Hill, United Kingdom, residing at 27

Carolina Place, Finchampstead, Wokingham, Berkshire, RG40 4PQ, United Kingdom, here represented by Mrs Sofia
AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally in Esch/Alzette, by virtue of a proxy given under
private seal, declares to subscribe to:

- twenty-seven (27) AA1 Shares in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each,
twenty-seven (27) AA2 Shares in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each;
twenty-seven (27) AA3 Shares in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each;
twenty-seven (27) AA4 Shares in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each; and
twenty-eight (28) AA5 Shares in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each;
and to pay them up by way of a contribution in kind consisting of ninety-six (96) shares of Magnum, having a par value

of one hundred and seventy-three Pound Sterling and forty-six Pence (GBP 173.46) (the Contributed Shares 7), which
shall be allocated as follows:

* an amount of one Pound Sterling and thirty-six Pence (GBP 1.36) shall be allocated to the nominal share capital

account of the Company; and

* an amount of one hundred and seventy-two Pound Sterling and ten Pence (GBP 172.10) shall be allocated to the

share premium reserve account of the Company connected to the AA Shares.

It was evidenced by a certificate issued by the Company (the Certificate 7) that:
“David Chandler is the legal and beneficial owner of the Contributed Shares 7;
as of the date of the certificate, the par value of the Contributed Shares 7 is of one hundred and seventy-three Pound

Sterling and forty-six Pence (GBP 173.46); and

the Contributed Shares 7 are contributed by David Chandler to the Company in exchange for the issue by the Company

of twenty-seven (27) AA1 Shares, twenty-seven (27) AA2 Shares, twenty-seven (27) AA3 Shares, twenty-seven (27) AA4
Shares and twenty-eight (28) AA5 Shares, all in registered form, having a nominal value of one penny (GBP 0.01) each.”

95204

L

U X E M B O U R G

- six hundred (600) MGT MPRS in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each, and to fully

pay them up by way of a contribution in kind consisting of sixty-one thousand nine hundred and twenty-six (61,926)
preferred equity certificates having a nominal value of one Pound Sterling (GBP 1) each issued by Magnum, having an
aggregate par value of sixty-one thousand nine hundred and twenty-six Pound Sterling and five Pence (GBP 61,926.05)
(the Contributed PECs 7), which shall be allocated as follows:

* an amount of six Pound Sterling (GBP 6) shall be allocated to the nominal share capital account of the Company;
* an amount of fifty-eight thousand four hundred and ninety-nine Pound Sterling and forty-one Pence (GBP 58,499.41)

shall be allocated to the share premium reserve account of the Company connected to the MGT MRPS; and

* an amount of three thousand four hundred and twenty Pound Sterling and sixty-four Pence (GBP 3,420.64) shall be

allocated to the general MRPS share premium reserve account of the Company.

It was evidenced by the Certificate 7 that:
“David Chandler is the legal and beneficial owner of the Contributed PECs 7;
as of the date of the certificate, the par value of the Contributed PECs 7 is of sixty-one thousand nine hundred and

twenty-six Pound Sterling and five Pence (GBP 61,926.05); and

the Contributed PECs 7 are contributed by David Chandler to the Company in exchange for the issue by the Company

of six hundred (600) MGT MPRS, in registered form, having a nominal value of one penny (GBP 0.01) each.”

8. Ian Haggerty, Contracts Manager, born on April 12, 1962 in London, United Kingdom, residing at 2 Buccaneer Close,

Woodley, Reading, Berkshire, RG5 4XP, United Kingdom, here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE,
private employee, residing professionally in Esch/Alzette, by virtue of a proxy given under private seal, declares to sub-
scribe to:

- eleven (11) AA1 Shares in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each,
eleven (11) AA2 Shares in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each;
eleven (11) AA3 Shares in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each;
eleven (11) AA4 Shares in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each; and
ten (10) AA5 Shares in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each;
and to pay them up by way of a contribution in kind consisting of thirty-eight (38) shares of Magnum, having a par value

of sixty-nine Pound Sterling and thirty-eight Pence (GBP 69.38) (the Contributed Shares 8), which shall be allocated as
follows:

* an amount of thirty-four Pence (GBP 0.54) shall be allocated to the nominal share capital account of the Company;

and

* an amount of sixty-eight Pound Sterling and eighty-four Pence (GBP 68.84) shall be allocated to the share premium

reserve account of the Company connected to the AA Shares.

It was evidenced by a certificate issued by the Company (the Certificate 8) that:
“Ian Haggerty is the legal and beneficial owner of the Contributed Shares 8;
as of the date of the certificate, the par value of the Contributed Shares 8 is of sixty-nine Pound Sterling and thirty-

eight Pence (GBP 69.38); and

the Contributed Shares 8 are contributed by Ian Haggerty to the Company in exchange for the issue by the Company

of eleven (11) AA1 Shares, eleven (11) AA2 Shares, eleven (11) AA3 Shares, eleven (11) AA4 Shares and ten (10) AA5
Shares, all in registered form, having a nominal value of one penny (GBP 0.01) each.”

- two hundred and forty (240) MGT MPRS in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each, and

to fully pay them up by way of a contribution in kind consisting of twenty-four thousand seven hundred and seventy
(24,770) preferred equity certificates having a nominal value of one Pound Sterling (GBP 1) each issued by Magnum, having
an aggregate par value of twenty-four thousand seven hundred and seventy Pound Sterling and forty-two Pence (GBP
24,770.42) (the Contributed PECs 8), which shall be allocated as follows:

* an amount of two Pound Sterling forty Pence (GBP 2.40) shall be allocated to the nominal share capital account of

the Company;

* an amount of twenty-three thousand and fifty-seven Pound Sterling and seventy Pence (GBP 23,057.70) shall be

allocated to the share premium reserve account of the Company connected to the MGT MRPS; and

* an amount of one thousand seven hundred and ten Pound Sterling and thirty-two Pence (GBP 1,710.32) shall be

allocated to the general MRPS share premium reserve account of the Company.

It was evidenced by the Certificate 8 that:
“Ian Haggerty is the legal and beneficial owner of the Contributed PECs 8;
as of the date of the certificate, the par value of the Contributed PECs 8 is of twenty-four thousand seven hundred

and seventy Pound Sterling and forty-two Pence (GBP 24,770.42); and

the Contributed PECs 8 are contributed by Ian Haggerty to the Company in exchange for the issue by the Company

of two hundred and forty (240) MGT MPRS, in registered form, having a nominal value of one penny (GBP 0.01) each.”

95205

L

U X E M B O U R G

9. Richard Milton, Senior Technical Manager, born on March 5, 1978 in Plymouth, United Kingdom, residing at 4

Vicarage Road, Maidenhead, Berkshire, SL6 7DS, United Kingdom, here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO
CONDE, private employee, residing professionally in Esch/Alzette, by virtue of a proxy given under private seal, declares
to subscribe to:

- eleven (11) AA1 Shares in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each,
eleven (11) AA2 Shares in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each;
eleven (11) AA3 Shares in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each;
eleven (11) AA4 Shares in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each; and
ten (10) AA5 Shares in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each;
and to pay them up by way of a contribution in kind consisting of thirty-eight (38) shares of Magnum, having a par value

of sixty-nine Pound Sterling and thirty-eight Pence (GBP 69.38) (the Contributed Shares 9), which shall be allocated as
follows:

* an amount of thirty-four Pence (GBP 0.54) shall be allocated to the nominal share capital account of the Company;

and

* an amount of sixty-eight Pound Sterling and eighty-four Pence (GBP 68.84) shall be allocated to the share premium

reserve account of the Company connected to the AA Shares.

It was evidenced by a certificate issued by the Company (the Certificate 9) that:
“Richard Milton is the legal and beneficial owner of the Contributed Shares 9;
as of the date of the certificate, the par value of the Contributed Shares 9 is of sixty-nine Pound Sterling and thirty-

eight Pence (GBP 69.38); and

the Contributed Shares 9 are contributed by Richard Milton to the Company in exchange for the issue by the Company

of eleven (11) AA1 Shares, eleven (11) AA2 Shares, eleven (11) AA3 Shares, eleven (11) AA4 Shares and ten (10) AA5
Shares, all in registered form, having a nominal value of one penny (GBP 0.01) each.”

- two hundred and forty (240) MGT MPRS in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each, and

to fully pay them up by way of a contribution in kind consisting of twenty-four thousand seven hundred and seventy
(24,770) preferred equity certificates having a nominal value of one Pound Sterling (GBP 1) each issued by Magnum, having
an aggregate par value of twenty-four thousand seven hundred and seventy Pound Sterling and forty-two Pence (GBP
24,770.42) (the Contributed PECs 9), which shall be allocated as follows:

* an amount of two Pound Sterling forty Pence (GBP 2.40) shall be allocated to the nominal share capital account of

the Company;

* an amount of twenty-three thousand and fifty-seven Pound Sterling and seventy Pence (GBP 23,057.70) shall be

allocated to the share premium reserve account of the Company connected to the MGT MRPS; and

* an amount of one thousand seven hundred and ten Pound Sterling and thirty-two Pence (GBP 1,710.32) shall be

allocated to the general MRPS share premium reserve account of the Company.

It was evidenced by the Certificate 9 that:
“Richard Milton is the legal and beneficial owner of the Contributed PECs 9;
as of the date of the certificate, the par value of the Contributed PECs 9 is of twenty-four thousand seven hundred

and seventy Pound Sterling and forty-two Pence (GBP 24,770.42); and

the Contributed PECs 9 are contributed by Richard Milton to the Company in exchange for the issue by the Company

of two hundred and forty (240) MGT MPRS, in registered form, having a nominal value of one penny (GBP 0.01) each.”

10. Lee Gardner, Site Manager, born on October 7, 1976 in Ascot, United Kingdom, residing at 114 Binfield Road,

Bracknell, Berkshire, RG42 2AS, United Kingdom, here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private
employee, residing professionally in Esch/Alzette, by virtue of a proxy given under private seal, declares to subscribe to:

- eleven (11) AA1 Shares in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each,
eleven (11) AA2 Shares in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each;
eleven (11) AA3 Shares in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each;
eleven (11) AA4 Shares in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each; and
ten (10) AA5 Shares in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each;
and to pay them up by way of a contribution in kind consisting of thirty-eight (38) shares of Magnum, having a par value

of sixty-nine Pound Sterling and thirty-eight Pence (GBP 69.38) (the Contributed Shares 10), which shall be allocated as
follows:

* an amount of thirty-four Pence (GBP 0.54) shall be allocated to the nominal share capital account of the Company;

and

* an amount of sixty-eight Pound Sterling and eighty-four Pence (GBP 68.84) shall be allocated to the share premium

reserve account of the Company connected to the AA Shares.

It was evidenced by a certificate issued by the Company (the Certificate 10) that:

95206

L

U X E M B O U R G

“Lee Gardner is the legal and beneficial owner of the Contributed Shares 10;
as of the date of the certificate, the par value of the Contributed Shares 10 is of sixty-nine Pound Sterling and thirty-

eight Pence (GBP 69.38); and

the Contributed Shares 10 are contributed by Lee Gardner to the Company in exchange for the issue by the Company

of eleven (11) AA1 Shares, eleven (11) AA2 Shares, eleven (11) AA3 Shares, eleven (11) AA4 Shares and ten (10) AA5
Shares, all in registered form, having a nominal value of one penny (GBP 0.01) each.”

- two hundred and forty (240) MGT MPRS in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each, and

to fully pay them up by way of a contribution in kind consisting of twenty-four thousand seven hundred and seventy
(24,770) preferred equity certificates having a nominal value of one Pound Sterling (GBP 1) each issued by Magnum, having
an aggregate par value of twenty-four thousand seven hundred and seventy Pound Sterling and forty-two Pence (GBP
24,770.42) (the Contributed PECs 10), which shall be allocated as follows:

* an amount of two Pound Sterling forty Pence (GBP 2.40) shall be allocated to the nominal share capital account of

the Company;

* an amount of twenty-three thousand and fifty-seven Pound Sterling and seventy Pence (GBP 23,057.70) shall be

allocated to the share premium reserve account of the Company connected to the MGT MRPS; and

* an amount of one thousand seven hundred and ten Pound Sterling and thirty-two Pence (GBP 1,710.32) shall be

allocated to the general MRPS share premium reserve account of the Company.

It was evidenced by the Certificate 10 that:
“Lee Gardner is the legal and beneficial owner of the Contributed PECs 10;
as of the date of the certificate, the par value of the Contributed PECs 10 is of twenty-four thousand seven hundred

and seventy Pound Sterling and forty-two Pence (GBP 24,770.42); and

the Contributed PECs 10 are contributed by Lee Gardner to the Company in exchange for the issue by the Company

of two hundred and forty (240) MGT MPRS, in registered form, having a nominal value of one penny (GBP 0.01) each.”

11. Robin Anderson, Site Manager, born on May 26, 1957 in Wokingham, United Kingdom, residing at 12 Elmley Close,

Emmbrook, Wokingham, Berkshire, RG41 1HP, United Kingdom, here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO
CONDE, private employee, residing professionally in Esch/Alzette, by virtue of a proxy given under private seal, declares
to subscribe to:

- ten (10) AA1 Shares in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each,
eleven (11) AA2 Shares in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each;
eleven (11) AA3 Shares in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each;
eleven (11) AA4 Shares in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each; and
eleven (11) AA5 Shares in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each;
and to pay them up by way of a contribution in kind consisting of thirty-eight (38) shares of Magnum, having a par value

of sixty-nine Pound Sterling and thirty-eight Pence (GBP 69.38) (the Contributed Shares 11), which shall be allocated as
follows:

* an amount of thirty-four Pence (GBP 0.54) shall be allocated to the nominal share capital account of the Company;

and

* an amount of sixty-eight Pound Sterling and eighty-four Pence (GBP 68.84) shall be allocated to the share premium

reserve account of the Company connected to the AA Shares.

It was evidenced by a certificate issued by the Company (the Certificate 11) that:
“Robin Anderson is the legal and beneficial owner of the Contributed Shares 11;
as of the date of the certificate, the par value of the Contributed Shares 11 is of sixty-nine Pound Sterling and thirty-

eight Pence (GBP 69.38); and

the Contributed Shares 11 are contributed by Robin Anderson to the Company in exchange for the issue by the

Company of ten (10) AA1 Shares, eleven (11) AA2 Shares, eleven (11) AA3 Shares, eleven (11) AA4 Shares and eleven
(11) AA5 Shares, all in registered form, having a nominal value of one penny (GBP 0.01) each.”

- two hundred and forty (240) MGT MPRS in registered form, with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each, and

to fully pay them up by way of a contribution in kind consisting of twenty-four thousand seven hundred and seventy
(24,770) preferred equity certificates having a nominal value of one Pound Sterling (GBP 1) each issued by Magnum, having
an aggregate par value of twenty-four thousand seven hundred and seventy Pound Sterling and forty-two Pence (GBP
24,770.42) (the Contributed PECs 11), which shall be allocated as follows:

* an amount of two Pound Sterling forty Pence (GBP 2.40) shall be allocated to the nominal share capital account of

the Company;

* an amount of twenty-three thousand and fifty-seven Pound Sterling and seventy Pence (GBP 23,057.70) shall be

allocated to the share premium reserve account of the Company connected to the MGT MRPS; and

* an amount of one thousand seven hundred and ten Pound Sterling and thirty-two Pence (GBP 1,710.32) shall be

allocated to the general MRPS share premium reserve account of the Company.

95207

L

U X E M B O U R G

It was evidenced by the Certificate 11 that:
“Robin Anderson is the legal and beneficial owner of the Contributed PECs 11;
as of the date of the certificate, the par value of the Contributed PECs 11 is of twenty-four thousand seven hundred

and seventy Pound Sterling and forty-two Pence (GBP 24,770.42); and

the  Contributed  PECs  11  are  contributed  by  Robin  Anderson  to  the  Company  in  exchange  for  the  issue  by  the

Company of two hundred and forty (240) MGT MPRS, in registered form, having a nominal value of one penny (GBP
0.01) each.”

11. Nicholas Jackson, prenamed and represented as stated above, here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO

CONDE, private employee, residing professionally in Esch/Alzette, by virtue of a proxy given under private seal, declares
to subscribe to:

- three hundred (300) BB1 Shares, having a nominal value of one penny (GBP 0,01.-) each;
three hundred (300) BB 2 Shares, having a nominal value of one penny (GBP 0,01.-) each;
three hundred (300) BB 3 Shares, having a nominal value of one penny (GBP 0,01.-) each;
three hundred (300) BB 4 Shares, having a nominal value of one penny (GBP 0,01.-) each;
and three hundred (300) BB 5 Shares, having a nominal value of one penny (GBP 0,01.-) each;
and to pay them up by way of a contribution in cash in an aggregate amount of six thousand Pound Sterling (GBP

6,000), which shall be allocated as follows:

* an amount of fifteen Pound Sterling (GBP 15) shall be allocated to the nominal share capital account of the Company;

and

* an amount of five thousand nine hundred and eighty-five Pound Sterling (GBP 5,985) shall be allocated to the share

premium reserve account of the Company connected to the BB Ordinary Shares.

The Certificate 1, the Certificate 2, the Certificate 3, the Certificate 4, the Certificate 5, the Certificate 6, the Certificate

7, the Certificate 8, the Certificate 9, the Certificate 10 and the Certificate 11, after having been signed ne varietur by
the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and the undersigned notary, shall remain attached to the present
deed for the purpose of registration.

The amount of eighteen thousand Pound Sterling (GBP 18,000) are forthwith at the free disposal of the Company,

evidence of which has been given to the undersigned notary.

The Shareholders, David Simpson, Paul Beaney, Jonathan Cranley, Paul Wills, Marc Taylor, Greg Meier, David Chandler,

Ian Haggerty, Richard Milton, Lee Gardner and Robin Anderson, now representing the entire share capital of the Company
and constituting the Meeting, have unanimously taken the following resolutions:

<i>Fifth resolution

The Meeting resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above decrease

of the nominal value of the shares and the share capital increase and to empower and authorize any manager of the
Company, each acting individually, to proceed on behalf of the Company, with the registration of the newly issued shares,
in the register of shareholders of the Company.

<i>Sixth resolution

The Meeting resolves to amend article 5.1. of the Articles which shall henceforth read as follows:

“ 5.1. The Company's corporate capital is fixed at forty-three thousand six hundred and forty-five Pound Sterling

thirteen Pence (GBP 43,645.13) represented by (i) one hundred and thirty thousand and two hundred (130,200) class A1
ordinary shares (the A1 Shares), (ii) one hundred and thirty thousand and two hundred (130,200) class A2 ordinary shares
(the A2 Shares), (iii) one hundred and thirty thousand and two hundred (130,200) class A3 ordinary shares (the A3
Shares), (iv) one hundred and thirty thousand and two hundred (130,200) class A4 ordinary shares (the A4 Shares), (v)
one hundred and thirty thousand and two hundred (130,200) class A5 ordinary shares (the A5 Shares, and together with
the A1 Shares, the A2 Shares, the A3 Shares and the A4 Shares, the A Ordinary Shares), (vi) twenty-seven thousand and
ninety-nine (27,099) class AA1 ordinary shares (the AA1 Shares), (vii) twenty-seven thousand and ninety-nine (27,099)
class AA2 ordinary shares (the AA2 Shares), (viii) twenty-seven thousand and ninety-nine (27,099) class AA3 ordinary
shares (the AA3 Shares), (ix) twenty-seven thousand and ninety-nine (27,099) class AA4 ordinary shares (the AA4 Shares),
(x) twenty-seven thousand and one hundred (27,100) class AA5 ordinary shares (the AA5 Shares, and together with the
he AA1 Shares, the AA2 Shares, the AA3 Shares and the AA4 Shares, the AA Ordinary Shares), (xi) nine thousand ninety-
five (9,095) Class B1 ordinary shares (the B1 Shares), (xii) nine thousand ninety-five (9,095) class B2 ordinary shares (the
B2 Shares), (xiii) nine thousand ninety-five (9,095) class B3 ordinary shares (the B3 Shares), (xiv) nine thousand ninety-
six (9,096) class B4 ordinary shares (the B4 Shares), (xv) nine thousand ninety-six (9,096) class B5 ordinary shares (the
B5 Shares, and together with the B1 Shares, the B2 Shares, the B3 Shares and the B4 Shares, the B Ordinary Shares),
(xvi) one thousand three hundred (1,300) class BB1 ordinary shares (the BB1 Shares), (xvii) one thousand three hundred
(1,300) class BB2 ordinary shares (the BB2 Shares), (xviii) one thousand three hundred (1,300) class BB3 ordinary shares
(the BB3 Shares), (xix) one thousand three hundred (1,300) class BB4 ordinary shares (the BB4 Shares), (xx) one thousand
three hundred (1,300) class BB5 ordinary shares (the BB5 Shares, and together with the BB1 Shares, the BB2 Shares, the

95208

L

U X E M B O U R G

BB3 Shares and the BB4 Shares, the BB Ordinary Shares), (xxi) six hundred and eighty thousand five hundred and ninety-
four (680,594) class C ordinary shares (the C Ordinary Shares), (xxii) one (1) class D ordinary share (the D Ordinary
Share), (xxiii) two million and seventy-four thousand and forty-nine (2,074,049) OCM mandatory redeemable preferred
shares  (the  OCM  MRPS),  (xxiv)  one  hundred  and  ninety-four  thousand  six  hundred  and  ninety-one  (194,691)  CHY
mandatory redeemable preferred shares (the CHY MRPS), (xxv) -one thousand two hundred and ninety (31,290) MGT
mandatory redeemable preferred shares (the MGT MRPS), and (xxvi) five hundred forty-five thousand four hundred sixty-
five (545,465) FEI mandatory redeemable preferred shares (the FEI MRPS, and together with the OCM MRPS, the CHY
MRPS and the MGT MRPS, the MRPS).

The holders of the shares issued by the Company, irrespectively of their class, are together referred to as the Share-

holders, and individually, as a Shareholder.”

<i>Seventh resolution

The Meeting resolves to appoint PricewaterhouseCoopers LLP, a limited liability partnership registered in England

with registered number OC303525, with registered office at 1 Embankment Place, London WC2N 6RH, United Kingdom,
as auditor of the Company as of the date hereof until the annual general meeting of 2015.

There being no further business, the meeting is closed.

<i>Estimate of costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately three thousand five hundred
euro (EUR 3,500.-).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded

in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will prevail.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Esch/Alzette, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, such proxyholder signed together with

the undersigned notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le trois février;
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg;

s’est tenue

une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) des associés de OCM Luxembourg Coppice Midco S.à r.l., une

société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 26A, Boulevard Royal, L-2449 Luxem-
bourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 175318, constituée le
5 février 2013 suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 891, page 42745 du 15 avril 2013 (la Société).
Les statuts de la Société (les Statuts) ont fait l’objet de modifications pour la dernière fois le 3 février 2014, suivant un
acte du notaire instrumentant, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

A COMPARU:

1. OCM Luxembourg Coppice Topco S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son

siège social au 26A, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 175303 (Topco), ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, em-
ployée privée, demeurant professionnellement à Esch/Alzette, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé;

2. Graham Stewart Cherry, company director, né le 15 juin 1959, résidant à Fridays, Fox Road, Mashbury, Chelmsford,

Essex  CM1  4TJ,  Royaume-Uni  (Graham  Cherry),  ici  représentée  par  Madame  Sofia  AFONSO-DA  CHAO  CONDE,
employée privée, demeurant professionnellement à Esch/Alzette, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration
donnée sous seing privé;

3. Richard Stephen Cherry, company director, né le 20 mars 1961, résidant à the Old Vicarage, High Street, Stebbing,

Dunmow, Essex CM6 3SF, Royaume-Uni (Richard Cherry), ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO
CONDE, employée privée, demeurant professionnellement à Esch/Alzette, en vertu d’une procuration donnée sous seing
privé;

4. Wendy Elizabeth Colgrave, company director, née le 13 janvier 1965, résidant à Ellis Farm, High Easter, Chelmsford,

Essex CM1 4RB, Royaume-Uni, ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée,
demeurant professionnellement à Esch/Alzette, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé;

5. The Trustees of The Alan Cherry Copthorn Will Trust, un trust de droit anglais, c/o Speechly Bircham LLP, 6 New

Street Square, London EC4A 3LX, Royaume-Uni, ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE,
employée privée, demeurant professionnellement à Esch/Alzette, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé;

95209

L

U X E M B O U R G

6. Andrew Carrington, Director, né le 18 février 1975 à Edimbourg, Royaume-Uni, résidant au 68 Avondale Avenue,

Esher, Surrey, KT10 0DA, Royaume-Uni, ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée
privée, demeurant professionnellement à Esch/Alzette, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé;

7. Angela Hyams Dowding, Group Chief Solicitor, née le 24 juin 1963 à Romford, Royaume-Uni, résidant au 69 Roth

Drive Hutton, Brentwood, Essex, CM13 2UE, Royaume-Uni, ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO
CONDE, employée privée, demeurant professionnellement à Esch/Alzette, en vertu d’une procuration donnée sous seing
privé;

8. Antony Travers, Managing Director, né le 18 mars 1960 à Manchester, Royaume-Uni, résidant au 39 St Thomas

Road, Brentwood, Essex, CM14 4DF, Royaume-Uni, ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE,
employée privée, demeurant professionnellement à Esch/Alzette, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé;

9. Christopher Bladon, Director, né le 16 mars 1977 à Rochford, Royaume-Uni, résidant au 9 Poplars Avenue, Hockley,

Essex,  SS5  4NA,  Royaume-Uni,  ici  représentée  par  Madame  Sofia  AFONSO-DA  CHAO  CONDE,  employée  privée,
demeurant professionnellement à Esch/Alzette, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé;

10. David Everett, Managing Director, né le 14 septembre 1957 à Bishop Auckland, Royaume-Uni, résidant à Somerville

House, 1 Hereward Mount, Stock, Ingatestone, Essex, CM4 9PS, Royaume-Uni, ici représentée par Madame Sofia AFON-
SO-DA CHAO CONDE, employée privée, demeurant professionnellement à Esch/Alzette, en vertu d’une procuration
donnée sous seing privé;

11. Ian Kelley, Managing Director, né le 17 octobre 1961 à Wigan, Royaume-Uni, résidant au 5 Fenwick Close, Wes-

thoughton,  Bolton,  Lancashire,  BL5  2GQ,  Royaume-Uni,  ici  représentée  par  Madame  Sofia  AFONSO-DA  CHAO
CONDE, employée privée, demeurant professionnellement à Esch/Alzette, en vertu d’une procuration donnée sous seing
privé;

12. James Dodd, Director, né le 19 avril 1967 à Romford, Royaume-Uni, résidant à "The Hoppit", The Village, Great

Waltham, Chelmsford, Essex, CM3 1AR, Royaume-Uni, ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE,
employée privée, demeurant professionnellement à Esch/Alzette, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé;

13. Richard Reeves, Director, né le 31 décembre 1962 à Grays, Royaume-Uni, résidant à "The Willows", Church Lane,

Hutton, Brentwood, Essex, CM13 1SB, Royaume-Uni, ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE,
employée privée, demeurant professionnellement à Esch/Alzette, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé;

14. Michael Hill, Director, né le 20 août 1952 à Redruth, Royaume-Uni, résidant au 12 Rowanwood Avenue, Sidcup,

Kent DA15 8WN, Royaume-Uni, ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée,
demeurant professionnellement à Esch/Alzette, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé;

15. Ian Sutcliffe, Executive Chairman, né le 24 juillet 1959 à Liverpool, Royaume-Uni, résidant à Windlesham Lodge,

Westwood Road, Windlesham, Surrey GU20 6LX, Royaume-Uni, ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO
CONDE, employée privée, demeurant professionnellement à Esch/Alzette, en vertu d’une procuration donnée sous seing
privé;

16. SPEECHLY BIRCHAM NOMINEE COMPANY LIMITED, un société constituée et immatricule en Angleterre et

Pays de Galle, numéro de société 01287713 et dont le siège social est au 6 New Street Square, London EC4A 3LX,
Royaume-Uni, ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, demeurant profes-
sionnellement à Esch/Alzette, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé;

17. David Simpson, managing director, né le 28 mars 1955 é Airdie, Royaume-Uni, résidant à Magnolia House, Vicarage

Lane, Hound Green, Hook, Hampshire, RG27 8JJ, Royaume-Uni, ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO
CONDE, employée privée, demeurant professionnellement à Esch/Alzette, en vertu d’une procuration donnée sous seing
privé; et

18. Nicholas Jackson, land &amp; planning director, né le 22 mars 1954, à Derby, Royaume-Uni, résidant à 6 Harvest Place,

School Hill, Wargrave, Berkshire, RG10 8AQ, Royaume-Uni, ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO
CONDE, employée privée, demeurant professionnellement à Esch/Alzette, en vertu d’une procuration donnée sous seing
privé.

Lesdites procurations, après avoir été signées "ne varietur" par le mandataire des parties comparantes et le notaire

instrumentant, resteront annexées au présent acte pour les formalités de l’enregistrement.

Les Associés, précités et représentés comme indiqué ci-dessus, représentant la totalité du capital social de la Société,

ont prié le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:

I. Le capital social de la société est actuellement fixé à quarante-trois mille deux cent seize livres sterling et trente-huit

centimes (GBP 43.216,38) représenté par (i) cent trente mille deux cents (130.200) parts sociales ordinaires de classe
A1 (les Parts Sociales A1), (ii) cent trente mille deux cents (130.200) parts sociales ordinaires de classe A2 (les Parts
Sociales A2), (iii) cent trente mille deux cents (130.200) parts sociales ordinaires de classe A3 (les Parts Sociales A3), (iv)
cent trente mille deux cents (130.200) parts sociales ordinaires de classe A4 (les Parts Sociales A4), (v) cent trente mille
deux cents (130.200) parts sociales ordinaires de classe A5 (les Parts Sociales A5, avec les Parts Sociales A1, les Parts
Sociales A2, les Parts Sociales A3 et les Parts Sociales A4, les Parts Sociales Ordinaires A), (vi) vingt-cinq mille six cent
quatre-vingt-deux (25.682) parts sociales ordinaires de classe AA1 (les Parts Sociales AA1), (vii) vingt-cinq mille six cent
quatre-vingt-deux (25.682) parts sociales ordinaires de classe AA2 (les Parts Sociales AA2), (viii) vingt-cinq mille six cent

95210

L

U X E M B O U R G

quatre-vingt-deux (25.682) parts sociales ordinaires de classe AA3 (les Parts Sociales AA3), (ix) vingt-cinq mille six cent
quatre-vingt-deux (25.682) parts sociales ordinaires de classe AA4 (les Parts Sociales AA4), (x) vingt-cinq mille six cent
quatre-vingt-trois (25.683) parts sociales ordinaires de classe AA5 (les Parts Sociales AA5, avec les Parts Sociales AA1,
les Parts Sociales AA2, les Parts Sociales AA3 et les Parts Sociales AA4, les Parts Sociales Ordinaires AA), (xi) neuf mille
quatre-vingt-quinze (9.095) parts sociales ordinaires de classe B1 (les Parts Sociales B1), (xii) neuf mille quatre-vingt-quinze
(9.095) parts sociales ordinaires de classe B2 (les Parts Sociales B2), (xiii) neuf mille quatre-vingt-quinze (9.095) parts
sociales ordinaires de classe B3 (les Parts Sociales B3), (xiv) neuf mille quatre-vingt-seize (9.096) parts sociales ordinaires
de classe B4 (les Parts Sociales B4), (xv) neuf mille quatre-vingt-seize (9.096) parts sociales ordinaires de classe B5 (les
Parts Sociales B5, avec les Parts Sociales B1, les Parts Sociales B2, les Parts Sociales B3 et les Parts Sociales B4, les Parts
Sociales Ordinaires B), (xvi) quatre cents (400) parts sociales ordinaires de classe BB1 (les Parts Sociales BB1), (xvii)
quatre cents (400) parts sociales ordinaires de classe BB2 (les Parts Sociales BB2), (xviii) quatre cents (400) parts sociales
ordinaires de classe BB3 (les Parts Sociales BB3), (xix) quatre cents (400) parts sociales ordinaires de classe BB4 (les Parts
Sociales BB4), (xx) quatre cents (400) parts sociales ordinaires de classe BB5 (les Parts Sociales BB5, avec les Parts Sociales
BB1, les Parts Sociales BB2, les Parts Sociales BB3 et les Parts Sociales BB4, les Parts Sociales Ordinaires BB), (xxi) six
cent quatre-vingt mille cinq cent quatre-vingt-quatorze (680.594) parts sociales ordinaires de classe C (les Parts Sociales
C), (xxii) une (1) part sociale ordinaire de classe D (la Part Sociale Ordinaire D, avec les Parts Sociales Oridnaires A, les
Parts Sociales Ordinaires AA, les Parts Sociales Ordinares B, les Parts Sociales Ordinaires BB et les Parts Sociales Ordi-
naires  C,  les  Parts  Sociales  Ordinaires),  (xxiii)  deux  million  soixante-quatorze  mille  quarante-neuf  (2.074.049)  parts
sociales privilégiées obligatoirement rachetables OCM (les OCM MRPS), (xxiv) cent quatre-vingt-quatorze mille six cent
quatre-vingt-onze (194.691) parts sociales privilégiées obligatoirement rachetables CHY (les CHY MRPS), (xxv) zero (0)
parts sociales privilégiées obligatoirement rachetables MGT (les MGT MRPS) et (xxvi) cinq cent quarante-cinq mille quatre
cent soixante-cinq (545.465) parts sociales privilégiées obligatoirement rachetables FEI (les FEI MRPS), toutes sous forme
nominative, ayant une valeur nominale d'un penny (GBP 0,01) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

II. L’ordre du jour de l’assemblée est libellé comme suit:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de quatre cent vingt-huit livres sterling et soixante-quinze

pence (GBP 428,75) afin de le porter de son montant actuel de quarante-trois mille deux cent seize livres sterling et
trente-huit centimes (GBP 43.216,38) à quarante-trois mille six cent quarante-cinq livres sterling et treize pence (GBP
43.645,13) par l’émission de (i) mille quatre cent dix-sept (1.417) parts sociales ordinaires AA1, (ii) mille quatre cent dix-
sept (1.417) parts sociales ordinaires AA2, (iii) mille quatre cent dix-sept (1.417) parts sociales ordinaires AA3, (iv) mille
quatre cent dix-sept (1.417) parts sociales ordinaires AA4, (v) mille quatre cent dix-sept (1.417) parts sociales ordinaires
Parts Sociales AA5, (vi) neuf cents (900) parts sociales ordinaires BB1, (vii) neuf cents (900) parts sociales ordinaires BB2,
(viii) neuf cents (900) parts sociales ordinaires BB3, (ix) neuf cents (900) parts sociales ordinaires BB4, (x) neuf cents
(900) parts sociales ordinaires BB5 et (xi) trente-et-un mille deux cent quatre-vingt-dix (31.290) parts sociales privilégiées
obligatoirement  rachetables  MGT,  toutes  sous  forme  nominative,  ayant  une  valeur  nominale  d’un  penny  (GBP  0,01)
chacune;

3. Souscription aux parts sociales et libération de l’augmentation du capital social mentionnée au point 2. ci-dessus et

paiement d’une prime d’émission;

4. Modification du registre des associés de la Société afin de refléter l’augmentation du capital social indiquée au point

2. ci-dessus, avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société, chacun agissant individuellement, pour procéder,
pour le compte de la Société à l’enregistrement des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de
la Société;

5. Modification subséquente de l’article 5.1. des statuts de la Société;
6. Nomination d’un commissaire aux comptes de la Société; et
7. Divers.
III. L’Assemblée a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

La totalité du capital social de la Société étant représentée, l’Assemblée renonce aux formalités de convocation, les

Associés se considérant eux-mêmes comme ayant été dûment convoqué et déclarant avoir une parfaite connaissance de
l’ordre du jour qui leur a été communiqué à l’avance.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide d’augmenter capital social de la Société d’un montant de quatre cent vingt-huit livres sterling et

soixante-quinze pence (GBP 428,75) afin de le porter de son montant actuel de quarante-trois mille deux cent seize livres
sterling et trente-huit centimes (GBP 43.216,38) à quarante-trois mille six cent quarante-cinq livres sterling et treize pence
(GBP 43.645,13) par l’émission de (i) mille quatre cent dix-sept (1.417) parts sociales ordinaires AA1, (ii) mille quatre
cent dix-sept (1.417) parts sociales ordinaires AA2, (iii) mille quatre cent dix-sept (1.417) parts sociales ordinaires AA3,
(iv) mille quatre cent dix-sept (1.417) parts sociales ordinaires AA4, (v) mille quatre cent dix-sept (1.417) parts sociales
ordinaires Parts Sociales AA5, (vi) neuf cents (900) parts sociales ordinaires BB1, (vii) neuf cents (900) parts sociales

95211

L

U X E M B O U R G

ordinaires BB2, (viii) neuf cents (900) parts sociales ordinaires BB3, (ix) neuf cents (900) parts sociales ordinaires BB4,
(x) neuf cents (900) parts sociales ordinaires BB5 et (xi) trente-et-un mille deux cent quatre-vingt-dix (31.290) parts
sociales privilégiées obligatoirement rachetables MGT, toutes sous forme nominative, ayant une valeur nominale d’un
penny (GBP 0,01) chacune.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée accepte et enregistre les souscriptions suivantes aux parts sociales et la libération intégrale de l’augmen-

tation du capital social ci-dessus comme suit:

<i>Souscription - Libération

1. David Simpson, prénommé et représenté comme décrit ci-dessus, déclare souscrire à:
- cinq cent seize (516) Parts Sociales AA1, ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune;
- cinq cent seize (516) Parts Sociales AA2, ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune;
- cinq cent quinze (515) Parts Sociales AA3, ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune;
- cinq cent quinze (515) Parts Sociales AA4, ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune; et
- cinq cent quinze (515) Parts Sociales AA5, ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune;
et de les libérer entièrement par voie de contribution en nature consistant en mille huit cent trente-six (1.836) actions

de OCM Magnum Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social
au 26A, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en cours d’immatriculation au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg (Magnum), ayant une valeur comptable de trois mille deux cent quatre-vingt-dix livres sterling et soixante-
cinq pence (GBP 3.290,65) (les Actions Contribuées 1), qui doit être alloué comme suit:

* un montant de vingt-cinq livres sterling et soixante-dix-sept pence (GBP 25,77) doit être alloué au compte du capital

social de la Société, et

* un montant de trois mille deux cent soixante-quatre livres sterling et quatre-vingt-huit pence (GBP 3.264,88) doit

être alloué au compte de prime d’émission de la Société connecté aux parts sociales de classe AA de la Société.

Il a été prouvé par un certificat émis par la Société (le Certificat 1) que:
«David Simpson est le propriétaire des Actions Contribuées 1;
à la date du certificat, la valeur comptable des Actions Contribuées 1 était de trois mille deux cent quatre-vingt-dix

livres sterling et soixante-cinq pence (GBP 3.290,65); et

les Actions Contribuées 1 sont contribuées par David Simpson à la Société en échange de l’émission par la Société de

cinq cent seize (516) Parts Sociales AA1, cinq cent seize (516) Parts Sociales AA2, cinq cent quinze (515) Parts Sociales
AA3, cinq cent quinze (515) Parts Sociales AA4 et cinq cent quinze (515) Parts Sociales AA5 sous forme nominative,
ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune.»

- onze mille trois cent soixante-dix-huit (11.378) MGT MRPS sous forme nominative ayant une valeur nominale d’un

penny (GBP 0,01) chacune, et de les libérer entièrement par voie de contribution en nature consistant en un million cent
soixante-quatorze mille sept cent soixante-deux (1.174.762) preferred equity certificates ayant une valeur nominale d’une
livre sterling chacun, émis par Magnum, ayant une valeur globale d’un million cent soixante-quatorze mille sept cent
soixante-deux livres sterling et vingt-trois pence (GBP 1.174.762,23) (les PECs Contribués 1), qui doit être alloué comme
suit:

* un montant de cent treize livres sterling et soixante-dix-huit pence (GBP 113,78) doit être alloué au compte du

capital social de la Société,

* un montant d’un million cent treize mille soixante-seize livres sterling et quatre-vingt-douze pence (GBP 1.113.076,92)

doit être alloué au compte de prime d’émission de la Société connecté aux MGT MRPS de la Société, et

*  un  montant  d’un  soixante-et-un  mille  cinq  cent  soixante-et-onze  livres  sterling  et  cinquante-trois  pence  (GBP

61.571,53) doit être alloué au compte de prime d’émission général des MRPS de la Société.

Il a été prouvé par un certificat émis par le Certificat 1 que:
«David Simpson est le propriétaire des PECs Contribués 1;
à la date du certificat, la valeur comptable des PECs Contribués 1 était d’un million cent soixante-quatorze mille sept

cent soixante-deux livres sterling et vingt-trois pence (GBP 1.174.762,23); et

les PECs Contribués 1 sont contribuées par David Simpson à la Société en échange de l’émission par la Société de

onze mille trois cent soixante-dix-huit (11.378) MGT MRPS sous forme nominative, ayant une valeur nominale d’un penny
(GBP 0,01) chacune.»

2. Paul Beaney, Contruction Director, né le 12 mars 1968 à Londres, Royaume-Uni, résidant à The White House,

Stubbs  Hill,  Binfield,  Berkshire,  RG42  5NN,  Royaume-Uni,  ici  représentée  par  Madame  Sofia  AFONSO-DA  CHAO
CONDE, employée privée, demeurant professionnellement à Esch/Alzette, en vertu d’une procuration donnée sous seing
privé, déclare souscrire à:

- trois cent quatre-vingt-six (386) Parts Sociales AA1, ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune;
- trois cent quatre-vingt-six (386) Parts Sociales AA2, ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune;

95212

L

U X E M B O U R G

- trois cent quatre-vingt-six (386) Parts Sociales AA3, ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune;
- trois cent quatre-vingt-sept (387) Parts Sociales AA4, ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune; et
- trois cent quatre-vingt-sept (387) Parts Sociales AA5, ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune;
et de les libérer entièrement par voie de contribution en nature consistant en mille trois cent soixante-dix-sept (1.377)

actions de Magnum, ayant une valeur comptable de deux mille quatre cent soixante-sept livres sterling et cinq pence (GBP
2.467,05) (les Actions Contribuées 2), qui doit être alloué comme suit:

* un montant de dix-neuf livres sterling et trente-deux pence (GBP 19,32) doit être alloué au compte du capital social

de la Société, et

* un montant de deux mille quatre cent quarante-sept livres sterling et soixante-treize pence (GBP 2.447,73) doit être

alloué au compte de prime d’émission de la Société connecté aux parts sociales de classe AA de la Société.

Il a été prouvé par un certificat émis par la Société (le Certificat 2) que:
«Paul Beaney est le propriétaire des Actions Contribuées 2;
à la date du certificat, la valeur comptable des Actions Contribuées 2 était de deux mille quatre cent soixante-sept

livres sterling et cinq pence (GBP 2.467,05); et

les Actions Contribuées 2 sont contribuées par Paul Beaney à la Société en échange de l’émission par la Société de

trois cent quatre-vingt-six (386) Parts Sociales AA1, trois cent quatre-vingt-six (386) Parts Sociales AA2, trois cent quatre-
vingt-six (386) Parts Sociales AA3, trois cent quatre-vingt-sept (387) Parts Sociales AA4 et trois cent quatre-vingt-sept
(387) Parts Sociales AA5 sous forme nominative, ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune.»

- trois cent (300) Parts Sociales BB1, ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune;
trois cent (300) Parts Sociales BB2, ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune;
trois cent (300) Parts Sociales BB3, ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune;
trois cent (300) Parts Sociales BB4, ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune; et
trois cent (300) Parts Sociales BB5, ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune;
et de les libérer entièrement par voie de contribution en numéraire d’un montant total de six mille livres sterling (GBP

6.000), qui doit être alloué comme suit:

* un montant de quinze livres sterling (GBP 15) doit être alloué au compte du capital social de la Société, et
* un montant de cinq mille neuf cent quatre-vingt-cinq livres sterling (GBP 5.985) doit être alloué au compte de prime

d’émission de la Société connecté aux parts sociales ordinaire de classe BB de la Société.

- huit mille cinq cent trente (8.530) MGT MRPS sous forme nominative ayant une valeur nominale d’un penny (GBP

0,01) chacune, et de les libérer entièrement par voie de contribution en nature consistant en huit cent quatre-vingt mille
sept cent trente-sept (880.737) preferred equity certificates ayant une valeur nominale d’une livre sterling chacun, émis
par Magnum, ayant une valeur globale de huit cent quatre-vingt mille sept cent trente-sept livres sterling et six pence
(GBP 880.737,06) (les PECs Contribués 2), qui doit être alloué comme suit:

* un montant de quatre-vingt-cinq livres sterling et trente pence (GBP 85,30) doit être alloué au compte du capital

social de la Société,

* un montant de huit cent trente-quatre mille quatre cent soixante-treize livres sterling et onze pence (GBP 834.473,11)

doit être alloué au compte de prime d’émission de la Société connecté aux MGT MRPS de la Société, et

* un montant de quarante-six mille cent soixante-dix-huit livres sterling et soixante-cinq pence (GBP 46.178,65) doit

être alloué au compte de prime d’émission général des MRPS de la Société.

Il a été prouvé par un certificat émis par le Certificat 2 que:
«Paul Beaney est le propriétaire des PECs Contribués 2;
à la date du certificat, la valeur comptable des PECs Contribués 2 était de huit cent quatre-vingt mille sept cent trente-

sept livres sterling et six pence (GBP 880.737,06); et

les PECs Contribués 2 sont contribuées par Paul Beaney à la Société en échange de l’émission par la Société de huit

mille cinq cent trente (8.530) MGT MRPS sous forme nominative, ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01)
chacune.»

3. Jonathan Cranley, Sales and Marketing Director, né le 31 août 1962 à Elstree, Royaume-Uni, résidant à The White

House, Stubbs Hill, Binfield, Berkshire, RG42 5NN, Royaume-Uni, ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO
CONDE, employée privée, demeurant professionnellement à Esch/Alzette, en vertu d’une procuration donnée sous seing
privé, déclare souscrire à:

- cent trente-et-un (131) Parts Sociales AA1, ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune;
- cent trente (130) Parts Sociales AA2, ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune;
- cent trente (130) Parts Sociales AA3, ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune;
- cent trente (130) Parts Sociales AA4, ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune; et
- cent trente-et-un (131) Parts Sociales AA5, ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune;

95213

L

U X E M B O U R G

et de les libérer entièrement par voie de contribution en nature consistant en quatre cent soixante-quatre (464) actions

de Magnum, ayant une valeur comptable de huit cent trente-deux livres sterling et soixante-deux pence (GBP 832,62)
(les Actions Contribuées 3), qui doit être alloué comme suit:

* un montant de six livres sterling et cinquante-deux pence (GBP 6,52) doit être alloué au compte du capital social de

la Société, et

* un montant de huit cent vingt-six livres sterling et dix pence (GBP 826,10) doit être alloué au compte de prime

d’émission de la Société connecté aux parts sociales de classe AA de la Société.

Il a été prouvé par un certificat émis par la Société (le Certificat 3) que:
«Jonathan Cranley est le propriétaire des Actions Contribuées 3;
à la date du certificat, la valeur comptable des Actions Contribuées 3 était de huit cent trente-deux livres sterling et

soixante-deux pence (GBP 832,62); et

les Actions Contribuées 3 sont contribuées par Jonathan Cranley à la Société en échange de l’émission par la Société

de cent trente-et-un (131) Parts Sociales AA1, cent trente (130) Parts Sociales AA2, cent trente (130) Parts Sociales AA3,
cent trente (130) Parts Sociales AA4 et cent trente-et-un (131) Parts Sociales AA5 sous forme nominative, ayant une
valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune.»

- cent (100) Parts Sociales BB1, ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune;
cent (100) Parts Sociales BB2, ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune;
cent (100) Parts Sociales BB3, ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune;
cent (100) Parts Sociales BB4, ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune; et
cent (100) Parts Sociales BB5, ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune;
et de les libérer entièrement par voie de contribution en numéraire d’un montant total de deux mille livres sterling

(GBP 2.000), qui doit être alloué comme suit:

* un montant de cinq livres sterling (GBP 5) doit être alloué au compte du capital social de la Société, et
* un montant de mille neuf cent quatre-vingt-quinze livres sterling (GBP 1.995) doit être alloué au compte de prime

d’émission de la Société connecté aux parts sociales ordinaire de classe BB de la Société.

- deux mille huit cent soixante-dix-neuf (2.879) MGT MRPS sous forme nominative ayant une valeur nominale d’un

penny (GBP 0,01) chacune, et de les libérer entièrement par voie de contribution en nature consistant en deux cent
quatre-vingt-dix-sept mille deux cent quarante-cinq (297.245) preferred equity certificates ayant une valeur nominale
d’une livre sterling chacun, émis par Magnum, ayant une valeur globale de deux cent quatre-vingt-dix-sept mille deux cent
quarante-cinq livres sterling et quatre pence (GBP 297.245,04) (les PECs Contribués 3), qui doit être alloué comme suit:

* un montant de vingt-huit livres sterling et soixante-dix-neuf pence (GBP 28,79) doit être alloué au compte du capital

social de la Société,

*  un  montant  de  deux  cent  quatre-vingt-un  mille  huit  cent  vingt-trois  livres  sterling  et  trente-sept  pence  (GBP

281.823,37) doit être alloué au compte de prime d’émission de la Société connecté aux MGT MRPS de la Société, et

* un montant de quinze mille trois cent quatre-vingt-douze livres sterling et quatre-vingt-huit pence (GBP 15.392,88)

doit être alloué au compte de prime d’émission général des MRPS de la Société.

Il a été prouvé par un certificat émis par le Certificat 3 que:
«Jonathan Cranley est le propriétaire des PECs Contribués 3;
à la date du certificat, la valeur comptable des PECs Contribués 3 était de deux cent quatre-vingt-dix-sept mille deux

cent quarante-cinq livres sterling et quatre pence (GBP 297.245,04); et

les PECs Contribués 3 sont contribuées par Jonathan Cranley à la Société en échange de l’émission par la Société de

deux mille huit cent soixante-dix-neuf (2.879) MGT MRPS sous forme nominative, ayant une valeur nominale d’un penny
(GBP 0,01) chacune.»

4. Paul Wills, Sales and Marketing Director, né le 28 août 1964 à Redruth, Royaume-Uni, résidant au 12 Drak Lane,

Wargrave, Berkshire, RG10 8JU, Royaume-Uni, ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, em-
ployée privée, demeurant professionnellement à Esch/Alzette, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé, déclare
souscrire à:

- cent trente-et-un (131) Parts Sociales AA1, ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune;
- cent trente-et-un (131) Parts Sociales AA2, ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune;
- cent trente (130) Parts Sociales AA3, ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune;
- cent trente (130) Parts Sociales AA4, ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune; et
- cent trente (130) Parts Sociales AA5, ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune;
et de les libérer entièrement par voie de contribution en nature consistant en quatre cent soixante-quatre (464) actions

de Magnum, ayant une valeur comptable de huit cent trente-deux livres sterling et soixante-deux pence (GBP 832,62)
(les Actions Contribuées 4), qui doit être alloué comme suit:

* un montant de six livres sterling et cinquante-deux pence (GBP 6,52) doit être alloué au compte du capital social de

la Société, et

95214

L

U X E M B O U R G

* un montant de huit cent vingt-six livres sterling et dix pence (GBP 826,10) doit être alloué au compte de prime

d’émission de la Société connecté aux parts sociales de classe AA de la Société.

Il a été prouvé par un certificat émis par la Société (le Certificat 4) que:
«Paul Wills est le propriétaire des Actions Contribuées 4;
à la date du certificat, la valeur comptable des Actions Contribuées 4 était de huit cent trente-deux livres sterling et

soixante-deux pence (GBP 832,62); et

les Actions Contribuées 4 sont contribuées par Paul Wills à la Société en échange de l’émission par la Société de cent

trente-et-un (131) Parts Sociales AA1, cent trente-et-un (131) Parts Sociales AA2, cent trente (130) Parts Sociales AA3,
cent trente (130) Parts Sociales AA4 et cent trente (130) Parts Sociales AA5 sous forme nominative, ayant une valeur
nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune.»

- cent (100) Parts Sociales BB1, ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune;
cent (100) Parts Sociales BB2, ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune;
cent (100) Parts Sociales BB3, ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune;
cent (100) Parts Sociales BB4, ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune; et
cent (100) Parts Sociales BB5, ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune;
et de les libérer entièrement par voie de contribution en numéraire d’un montant total de deux mille livres sterling

(GBP 2.000), qui doit être alloué comme suit:

* un montant de cinq livres sterling (GBP 5) doit être alloué au compte du capital social de la Société, et
* un montant de mille neuf cent quatre-vingt-quinze livres sterling (GBP 1.995) doit être alloué au compte de prime

d’émission de la Société connecté aux parts sociales ordinaire de classe BB de la Société.

- deux mille huit cent soixante-dix-neuf (2.879) MGT MRPS sous forme nominative ayant une valeur nominale d’un

penny (GBP 0,01) chacune, et de les libérer entièrement par voie de contribution en nature consistant en deux cent
quatre-vingt-dix-sept mille deux cent quarante-cinq (297.245) preferred equity certificates ayant une valeur nominale
d’une livre sterling chacun, émis par Magnum, ayant une valeur globale de deux cent quatre-vingt-dix-sept mille deux cent
quarante-cinq livres sterling et quatre pence (GBP 297.245,04) (les PECs Contribués 4), qui doit être alloué comme suit:

* un montant de vingt-huit livres sterling et soixante-dix-neuf pence (GBP 28.79) doit être alloué au compte du capital

social de la Société,

*  un  montant  de  deux  cent  quatre-vingt-un  mille  huit  cent  vingt-trois  livres  sterling  et  trente-sept  pence  (GBP

281.823,37) doit être alloué au compte de prime d’émission de la Société connecté aux MGT MRPS de la Société, et

* un montant de quinze mille trois cent quatre-vingt-douze livres sterling et quatre-vingt-huit pence (GBP 15.392,88)

doit être alloué au compte de prime d’émission général des MRPS de la Société.

Il a été prouvé par un certificat émis par le Certificat 4 que:
«Paul Wills est le propriétaire des PECs Contribués 4;
à la date du certificat, la valeur comptable des PECs Contribués 4 était de deux cent quatre-vingt-dix-sept mille deux

cent quarante-cinq livres sterling et quatre pence (GBP 297.245,04); et

les PECs Contribués 4 sont contribuées par Paul Wills à la Société en échange de l’émission par la Société de deux

mille huit cent soixante-dix-neuf (2,879) MGT MRPS sous forme nominative, ayant une valeur nominale d’un penny (GBP
0,01) chacune.»

5. Marc Taylor, Commercial Director, né le 15 mai 1972 à Hillingdon, Royaume-Uni, résidant à Highwood, 9 Rodney

Gardens, Pinner, Middlesex, HA5 2RT, Royaume-Uni, ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE,
employée privée, demeurant professionnellement à Esch/Alzette, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé,
déclare souscrire à:

- cent trente (130) Parts Sociales AA1, ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune;
- cent trente (130) Parts Sociales AA2, ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune;
- cent trente-et-un (131) Parts Sociales AA3, ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune;
- cent trente (130) Parts Sociales AA4, ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune; et
- cent trente-et-un (131)Parts Sociales AA5, ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune;
et de les libérer entièrement par voie de contribution en nature consistant en quatre cent soixante-quatre (464) actions

de Magnum, ayant une valeur comptable de huit cent trente-deux livres sterling et soixante-deux pence (GBP 832,62)
(les Actions Contribuées 5), qui doit être alloué comme suit:

* un montant de six livres sterling et cinquante-deux pence (GBP 6,52) doit être alloué au compte du capital social de

la Société, et

* un montant de huit cent vingt-six livres sterling et dix pence (GBP 826,10) doit être alloué au compte de prime

d’émission de la Société connecté aux parts sociales de classe AA de la Société.

Il a été prouvé par un certificat émis par la Société (le Certificat 5) que:
«Marc Taylor est le propriétaire des Actions Contribuées 5;

95215

L

U X E M B O U R G

à la date du certificat, la valeur comptable des Actions Contribuées 5 était de huit cent trente-deux livres sterling et

soixante-deux pence (GBP 832,62); et

les Actions Contribuées 5 sont contribuées par Marc Taylor à la Société en échange de l’émission par la Société de

cent trente (130) Parts Sociales AA1, cent trente (130) Parts Sociales Parts Sociales AA2, cent trente-et-un (131) Parts
Sociales AA3, cent trente (130) Parts Sociales AA4 et cent trente-et-un (131) Parts Sociales AA5 sous forme nominative,
ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune.»

- cent (100) Parts Sociales BB1, ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune;
cent (100) Parts Sociales BB2, ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune;
cent (100) Parts Sociales BB3, ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune;
cent (100) Parts Sociales BB4, ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune; et
cent (100) Parts Sociales BB5, ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune;
et de les libérer entièrement par voie de contribution en numéraire d’un montant total de deux mille livres sterling

(GBP 2.000), qui doit être alloué comme suit:

* un montant de cinq livres sterling (GBP 5) doit être alloué au compte du capital social de la Société, et
* un montant de mille neuf cent quatre-vingt-quinze livres sterling (GBP 1.995) doit être alloué au compte de prime

d’émission de la Société connecté aux parts sociales ordinaire de classe BB de la Société.

- deux mille huit cent soixante-dix-neuf (2,879) MGT MRPS sous forme nominative ayant une valeur nominale d’un

penny (GBP 0,01) chacune, et de les libérer entièrement par voie de contribution en nature consistant en deux cent
quatre-vingt-dix-sept mille deux cent quarante-cinq (297.245) preferred equity certificates ayant une valeur nominale
d’une livre sterling chacun, émis par Magnum, ayant une valeur globale de deux cent quatre-vingt-dix-sept mille deux cent
quarante-cinq livres sterling et quatre pence (GBP 297.245,04) (les PECs Contribués 5), qui doit être alloué comme suit:

* un montant de vingt-huit livres sterling et soixante-dix-neuf pence (GBP 28.79) doit être alloué au compte du capital

social de la Société,

*  un  montant  de  deux  cent  quatre-vingt-un  mille  huit  cent  vingt-trois  livres  sterling  et  trente-sept  pence  (GBP

281.823,37) doit être alloué au compte de prime d’émission de la Société connecté aux MGT MRPS de la Société, et

* un montant de quinze mille trois cent quatre-vingt-douze livres sterling et quatre-vingt-huit pence (GBP 15.392,88)

doit être alloué au compte de prime d’émission général des MRPS de la Société.

Il a été prouvé par un certificat émis par le Certificat 5 que:
«Marc Taylor est le propriétaire des PECs Contribués 5;
à la date du certificat, la valeur comptable des PECs Contribués 5 était de deux cent quatre-vingt-dix-sept mille deux

cent quarante-cinq livres sterling et quatre pence (GBP 297.245,04); et

les PECs Contribués 5 sont contribuées par Marc Taylor à la Société en échange de l’émission par la Société de deux

mille huit cent soixante-dix-neuf (2,879) MGT MRPS sous forme nominative, ayant une valeur nominale d’un penny (GBP
0,01) chacune.»

6. Greg Meier, Chief Architect, né le 2 juin1962 à Uffikon, LU, Nouvelle-Zélande, résidant au 10 Lewis Close, Harefield,

Uxbridge, Middlesex, UB9 6RD, Royaume-Uni, ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, em-
ployée privée, demeurant professionnellement à Esch/Alzette, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé, déclare
souscrire à:

- cinquante-trois (53) Parts Sociales AA1, ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune;
- cinquante-trois (53) Parts Sociales AA2, ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune;
- cinquante-quatre (54) Parts Sociales AA3, ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune;
- cinquante-quatre (54) Parts Sociales AA4, ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune; et
- cinquante-quatre (54) Parts Sociales AA5, ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune;
et de les libérer entièrement par voie de contribution en nature consistant en quatre cent soixante-quatre (464) actions

de Magnum, ayant une valeur comptable de trois cent quarante-deux livres sterling et soixante-deux pence (GBP 342,62)
(les Actions Contribuées 6), qui doit être alloué comme suit:

* un montant de deux livres sterling et soixante-huit pence (GBP 2,68) doit être alloué au compte du capital social de

la Société, et

* un montant de trois cent trente-neuf livres sterling et quatre-vingt-quatorze pence (GBP 339,94) doit être alloué au

compte de prime d’émission de la Société connecté aux parts sociales de classe AA de la Société.

Il a été prouvé par un certificat émis par la Société (le Certificat 6) que:
«Greg Meier est le propriétaire des Actions Contribuées 6;
à la date du certificat, la valeur comptable des Actions Contribuées 6 était de trois cent quarante-deux livres sterling

et soixante-deux pence (GBP 342,62); et

les Actions Contribuées 6 sont contribuées par Greg Meier à la Société en échange de l’émission par la Société de

cinquante-trois (53) Parts Sociales AA1, cinquante-trois (53) Parts Sociales Parts Sociales AA2, cinquante-quatre (54)

95216

L

U X E M B O U R G

Parts Sociales AA3, cinquante-quatre (54) Parts Sociales AA4 et cinquante-quatre (54) Parts Sociales AA5 sous forme
nominative, ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune.»

- mille cent quatre-vingt-cinq (1.185) MGT MRPS sous forme nominative ayant une valeur nominale d’un penny (GBP

0,01) chacune, et de les libérer entièrement par voie de contribution en nature consistant en cent vingt-deux mille trois
cent seize (122.316) preferred equity certificates ayant une valeur nominale d’une livre sterling chacun, émis par Magnum,
ayant une valeur globale de cent vingt-deux mille trois cent seize livres sterling et trente-trois pence (GBP 122.316,33)
(les PECs Contribués 6), qui doit être alloué comme suit:

* un montant de onze livres sterling et quatre-vingt-cinq pence (GBP 11,85) doit être alloué au compte du capital social

de la Société,

* un montant de cent quinze mille quatre cent soixante-trois livres sterling et vingt pence (GBP 115.463,20) doit être

alloué au compte de prime d’émission de la Société connecté aux MGT MRPS de la Société, et

* un montant de six mille huit cent quarante-et-un livres sterling et vingt-huit pence (GBP 6.841,28) doit être alloué

au compte de prime d’émission général des MRPS de la Société.

Il a été prouvé par un certificat émis par le Certificat 6 que:
«Greg Meier est le propriétaire des PECs Contribués 6;
à la date du certificat, la valeur comptable des PECs Contribués 6 était de cent vingt-deux mille trois cent seize livres

sterling et trente-trois pence (GBP 122.316,33); et

les PECs Contribués 6 sont contribuées par Greg Meier à la Société en échange de l’émission par la Société de mille

cent quatre-vingt-cinq (1.185) MGT MRPS sous forme nominative, ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01)
chacune.»

7. David Chandler, Senior Land Manager, né le 24 octobre 1953 à Kingston Hill, Royaume-Uni, résidant au 27 Carolina

Place, Finchampstead, Wokingham, Berkshire, RG40 4PQ, Royaume-Uni, ici représentée par Madame Sofia AFONSO-
DA  CHAO  CONDE,  employée  privée,  demeurant  professionnellement  à  Esch/Alzette,  en  vertu  d’une  procuration
donnée sous seing privé, déclare souscrire à:

- vingt-sept (27) Parts Sociales AA1, ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune;
- vingt-sept (27) Parts Sociales AA2, ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune;
- vingt-sept (27) Parts Sociales AA3, ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune;
- vingt-sept (27) Parts Sociales AA4, ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune; et
- vingt-sept (28) Parts Sociales AA5, ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune;
et  de  les  libérer  entièrement  par  voie  de  contribution  en  nature  consistant  en  quatre-vingt-seize  (96)  actions  de

Magnum, ayant une valeur comptable de cent soixante-treize livres sterling et quarante-six pence (GBP 173,46) (les
Actions Contribuées 7), qui doit être alloué comme suit:

* un montant d’une livre sterling et trente-six pence (GBP 1,36) doit être alloué au compte du capital social de la

Société, et

* un montant de cent soixante-douze livres sterling et dix pence (GBP 172,10) doit être alloué au compte de prime

d’émission de la Société connecté aux parts sociales de classe AA de la Société.

Il a été prouvé par un certificat émis par la Société (le Certificat 7) que:
«David Chandler est le propriétaire des Actions Contribuées 7;
à la date du certificat, la valeur comptable des Actions Contribuées 7 était de cent soixante-treize livres sterling et

quarante-six pence (GBP 173,46); et

les Actions Contribuées 7 sont contribuées par David Chandler à la Société en échange de l’émission par la Société

de vingt-sept (27) Parts Sociales AA1, vingt-sept (27) Parts Sociales Parts Sociales AA2, vingt-sept (27) Parts Sociales AA3,
vingt-sept (27) Parts Sociales AA4 et vingt-huit (28) Parts Sociales AA5 sous forme nominative, ayant une valeur nominale
d’un penny (GBP 0,01) chacune.»

- six cent (600) MGT MRPS sous forme nominative ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune, et de

les libérer entièrement par voie de contribution en nature consistant en soixante-et-un mille neuf cent vingt-six (61.926)
preferred equity certificates ayant une valeur nominale d’une livre sterling chacun, émis par Magnum, ayant une valeur
globale de soixante-et-un mille neuf cent vingt-six livres sterling et cinq pence (GBP 61.926.05) (les PECs Contribués 7),
qui doit être alloué comme suit:

* un montant de six livres sterling (GBP 6) doit être alloué au compte du capital social de la Société,
* un montant de cinquante-huit mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf livres sterling et quarante-et-un pence (GBP

58.499,41) doit être alloué au compte de prime d’émission de la Société connecté aux MGT MRPS de la Société, et

* un montant de trois mille quatre cent vingt livres sterling et soixante-quatorze pence (GBP 3.420,64) doit être alloué

au compte de prime d’émission général des MRPS de la Société.

Il a été prouvé par un certificat émis par le Certificat 7 que:
«David Chandler est le propriétaire des PECs Contribués 7;

95217

L

U X E M B O U R G

à la date du certificat, la valeur comptable des PECs Contribués 7 était de soixante-et-un mille neuf cent vingt-six livres

sterling et cinq pence (GBP 61.926.05); et

les PECs Contribués 7 sont contribuées par David Chandler à la Société en échange de l’émission par la Société de

six cent (600) MGT MRPS sous forme nominative, ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune.»

8. Ian Haggerty, Contracts Manager, né le 12 avril 1962 à Londres, Royaume-Uni, résidant au 2 Buccaneer Close,

Woodley, Reading, Berkshire, RG5 4XP, Royaume-Uni, ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE,
employée privée, demeurant professionnellement à Esch/Alzette, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé,
déclare souscrire à:

- onze (11) Parts Sociales AA1, ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune;
- onze (11) Parts Sociales AA2, ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune;
- onze (11) Parts Sociales AA3, ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune;
- onze (11) Parts Sociales AA4, ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune; et
- dix (10) Parts Sociales AA5, ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune;
et de les libérer entièrement par voie de contribution en nature consistant en trente-huit (38) actions de Magnum,

ayant une valeur comptable de soixante-neuf livres sterling et trente-huit pence (GBP 69,38) (les Actions Contribuées
8), qui doit être alloué comme suit:

* un montant de cinquante-quatre pence (GBP 0,54) doit être alloué au compte du capital social de la Société, et
* un montant de soixante-huit livres sterling et quatre-vingt-quatorze pence (GBP 68,84) doit être alloué au compte

de prime d’émission de la Société connecté aux parts sociales de classe AA de la Société.

Il a été prouvé par un certificat émis par la Société (le Certificat 8) que:
«Ian Haggerty est le propriétaire des Actions Contribuées 8;
à la date du certificat, la valeur comptable des Actions Contribuées 8 était de soixante-neuf livres sterling et trente-

huit pence (GBP 69,38); et

les Actions Contribuées 8 sont contribuées par Ian Haggerty à la Société en échange de l’émission par la Société de

onze (11) Parts Sociales AA1, onze (11) Parts Sociales Parts Sociales AA2, onze (11) Parts Sociales AA3, onze (11) Parts
Sociales AA4 et dix (10) Parts Sociales AA5 sous forme nominative, ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01)
chacune.»

- deux cent quarante (240) MGT MRPS sous forme nominative ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01)

chacune, et de les libérer entièrement par voie de contribution en nature consistant en vingt-quatre mille sept cent
soixante-dix (24.770) preferred equity certificates ayant une valeur nominale d’une livre sterling chacun, émis par Magnum,
ayant  une  valeur  globale  de  vingt-quatre  mille  sept  cent  soixante-dix  livres  sterling  et  quarante-deux  pence  (GBP
24.770,42) (les PECs Contribués 8), qui doit être alloué comme suit:

* un montant de deux livres sterling et quarante pence (GBP 2,40) doit être alloué au compte du capital social de la

Société,

* un montant de vingt-trois mille cinquante-sept livres sterling et soixante-dix pence (GBP 23.057,70) doit être alloué

au compte de prime d’émission de la Société connecté aux MGT MRPS de la Société, et

* un montant de mille sept cent dix livres sterling et trente-deux pence (GBP 1.710,32) doit être alloué au compte de

prime d’émission général des MRPS de la Société.

Il a été prouvé par un certificat émis par le Certificat 8 que:
«Ian Haggerty est le propriétaire des PECs Contribués 8;
à la date du certificat, la valeur comptable des PECs Contribués 8 était de vingt-quatre mille sept cent soixante-dix

livres sterling et quarante-deux pence (GBP 24.770,42); et

les PECs Contribués 8 sont contribuées par Ian Haggerty à la Société en échange de l’émission par la Société de deux

cent quarante (240) MGT MRPS sous forme nominative, ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune.»

9. Richard Milton, Senior Technical Manager, né le 5 mars 1978 à Plymouth, Royaume-Uni, résidant au 4 Vicarage Road,

Maidenhead, Berkshire, SL6 7DS, Royaume-Uni, ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, em-
ployée privée, demeurant professionnellement à Esch/Alzette, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé, déclare
souscrire à:

- onze (11) Parts Sociales AA1, ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune;
- onze (11) Parts Sociales AA2, ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune;
- onze (11) Parts Sociales AA3, ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune;
- onze (11) Parts Sociales AA4, ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune; et
- dix (10) Parts Sociales AA5, ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune;
et de les libérer entièrement par voie de contribution en nature consistant en trente-huit (38) actions de Magnum,

ayant une valeur comptable de soixante-neuf livres sterling et trente-huit pence (GBP 69,38) (les Actions Contribuées
9), qui doit être alloué comme suit:

* un montant de cinquante-quatre pence (GBP 0,54) doit être alloué au compte du capital social de la Société, et

95218

L

U X E M B O U R G

* un montant de soixante-huit livres sterling et quatre-vingt-quatorze pence (GBP 68,84) doit être alloué au compte

de prime d’émission de la Société connecté aux parts sociales de classe AA de la Société.

Il a été prouvé par un certificat émis par la Société (le Certificat 9) que:
«Richard Milton est le propriétaire des Actions Contribuées 9;
à la date du certificat, la valeur comptable des Actions Contribuées 9 était de soixante-neuf livres sterling et trente-

huit pence (GBP 69,38); et

les Actions Contribuées 9 sont contribuées par Richard Milton à la Société en échange de l’émission par la Société de

onze (11) Parts Sociales AA1, onze (11) Parts Sociales Parts Sociales AA2, onze (11) Parts Sociales AA3, onze (11) Parts
Sociales AA4 et dix (10) Parts Sociales AA5 sous forme nominative, ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01)
chacune.»

- deux cent quarante (240) MGT MRPS sous forme nominative ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01)

chacune, et de les libérer entièrement par voie de contribution en nature consistant en vingt-quatre mille sept cent
soixante-dix (24.770) preferred equity certificates ayant une valeur nominale d’une livre sterling chacun, émis par Magnum,
ayant  une  valeur  globale  de  vingt-quatre  mille  sept  cent  soixante-dix  livres  sterling  et  quarante-deux  pence  (GBP
24.770,42) (les PECs Contribués 9), qui doit être alloué comme suit:

* un montant de deux livres sterling et quarante pence (GBP 2,40) doit être alloué au compte du capital social de la

Société,

* un montant de vingt-trois mille cinquante-sept livres sterling et soixante-dix pence (GBP 23.057,70) doit être alloué

au compte de prime d’émission de la Société connecté aux MGT MRPS de la Société, et

* un montant de mille sept cent dix livres sterling et trente-deux pence (GBP 1.710,32) doit être alloué au compte de

prime d’émission général des MRPS de la Société.

Il a été prouvé par un certificat émis par le Certificat 9 que:
«Richard Milton est le propriétaire des PECs Contribués 9;
à la date du certificat, la valeur comptable des PECs Contribués 9 était de vingt-quatre mille sept cent soixante-dix

livres sterling et quarante-deux pence (GBP 24.770,42); et

les PECs Contribués 9 sont contribuées par Richard Milton à la Société en échange de l’émission par la Société de

deux cent quarante (240) MGT MRPS sous forme nominative, ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune.»

10. Lee Gardner, Site Manager, né le 7 octobre 1976 à Ascot, Royaume-Uni, résidant au 114 Binfield Road, Bracknell,

Berkshire, RG42 2AS, Royaume-Uni, ici représentée par Madame Sofia AFONSODA CHAO CONDE, employée privée,
demeurant professionnellement à Esch/Alzette, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé, déclare souscrire à:

- onze (11) Parts Sociales AA1, ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune;
- onze (11) Parts Sociales AA2, ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune;
- onze (11) Parts Sociales AA3, ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune;
- onze (11) Parts Sociales AA4, ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune; et
- dix (10) Parts Sociales AA5, ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune;
et de les libérer entièrement par voie de contribution en nature consistant en trente-huit (38) actions de Magnum,

ayant une valeur comptable de soixante-neuf livres sterling et trente-huit pence (GBP 69,38) (les Actions Contribuées
10), qui doit être alloué comme suit:

* un montant de cinquante-quatre pence (GBP 0,54) doit être alloué au compte du capital social de la Société, et
* un montant de soixante-huit livres sterling et quatre-vingt-quatorze pence (GBP 68,84) doit être alloué au compte

de prime d’émission de la Société connecté aux parts sociales de classe AA de la Société.

Il a été prouvé par un certificat émis par la Société (le Certificat 10) que:
«Lee Gardner est le propriétaire des Actions Contribuées 10;
à la date du certificat, la valeur comptable des Actions Contribuées 10 était de soixante-neuf livres sterling et trente-

huit pence (GBP 69,38); et

les Actions Contribuées 10 sont contribuées par Lee Gardner à la Société en échange de l’émission par la Société de

onze (11) Parts Sociales AA1, onze (11) Parts Sociales Parts Sociales AA2, onze (11) Parts Sociales AA3, onze (11) Parts
Sociales AA4 et dix (10) Parts Sociales AA5 sous forme nominative, ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01)
chacune.»

- deux cent quarante (240) MGT MRPS sous forme nominative ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01)

chacune, et de les libérer entièrement par voie de contribution en nature consistant en vingt-quatre mille sept cent
soixante-dix (24.770) preferred equity certificates ayant une valeur nominale d’une livre sterling chacun, émis par Magnum,
ayant  une  valeur  globale  de  vingt-quatre  mille  sept  cent  soixante-dix  livres  sterling  et  quarante-deux  pence  (GBP
24.770,42) (les PECs Contribués 10), qui doit être alloué comme suit:

* un montant de deux livres sterling et quarante pence (GBP 2,40) doit être alloué au compte du capital social de la

Société,

95219

L

U X E M B O U R G

* un montant de vingt-trois mille cinquante-sept livres sterling et soixante-dix pence (GBP 23.057,70) doit être alloué

au compte de prime d’émission de la Société connecté aux MGT MRPS de la Société, et

* un montant de mille sept cent dix livres sterling et trente-deux pence (GBP 1.710,32) doit être alloué au compte de

prime d’émission général des MRPS de la Société.

Il a été prouvé par un certificat émis par le Certificat 10 que:
«Lee Gardner est le propriétaire des PECs Contribués 10;
à la date du certificat, la valeur comptable des PECs Contribués 10 était de vingt-quatre mille sept cent soixante-dix

livres sterling et quarante-deux pence (GBP 24.770,42); et

les PECs Contribués 10 sont contribuées par Lee Gardner à la Société en échange de l’émission par la Société de deux

cent quarante (240) MGT MRPS sous forme nominative, ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune.»

11. Robin Anderson, Site Manager, né le 26 mai 1957 à Wokingham, Royaume-Uni, résidant au 12 Elmley Close,

Emmbrook, Wokingham, Berkshire, RG41 1HP, Royaume-Uni, ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO
CONDE, employée privée, demeurant professionnellement à Esch/Alzette en vertu d’une procuration donnée sous seing
privé, déclare souscrire à:

- dix (10) Parts Sociales AA1, ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune;
- onze (11) Parts Sociales AA2, ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune;
- onze (11) Parts Sociales AA3, ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune;
- onze (11) Parts Sociales AA4, ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune; et
- onze (11) Parts Sociales AA5, ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune;
et de les libérer entièrement par voie de contribution en nature consistant en trente-huit (38) actions de Magnum,

ayant une valeur comptable de soixante-neuf livres sterling et trente-huit pence (GBP 69,38) (les Actions Contribuées
11), qui doit être alloué comme suit:

* un montant de cinquante-quatre pence (GBP 0,54) doit être alloué au compte du capital social de la Société, et
* un montant de soixante-huit livres sterling et quatre-vingt-quatorze pence (GBP 68,84) doit être alloué au compte

de prime d’émission de la Société connecté aux parts sociales de classe AA de la Société.

Il a été prouvé par un certificat émis par la Société (le Certificat 11) que:
«Robin Anderson est le propriétaire des Actions Contribuées 11;
à la date du certificat, la valeur comptable des Actions Contribuées 11 était de soixante-neuf livres sterling et trente-

huit pence (GBP 69,38); et

les Actions Contribuées 11 sont contribuées par Robin Anderson à la Société en échange de l’émission par la Société

de dix (10) Parts Sociales AA1, onze (11) Parts Sociales Parts Sociales AA2, onze (11) Parts Sociales AA3, onze (11) Parts
Sociales AA4 et onze (11) Parts Sociales AA5 sous forme nominative, ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01)
chacune.»

- deux cent quarante (240) MGT MRPS sous forme nominative ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01)

chacune, et de les libérer entièrement par voie de contribution en nature consistant en vingt-quatre mille sept cent
soixante-dix (24.770) preferred equity certificates ayant une valeur nominale d’une livre sterling chacun, émis par Magnum,
ayant  une  valeur  globale  de  vingt-quatre  mille  sept  cent  soixante-dix  livres  sterling  et  quarante-deux  pence  (GBP
24.770,42) (les PECs Contribués 11), qui doit être alloué comme suit:

* un montant de deux livres sterling et quarante pence (GBP 2,40) doit être alloué au compte du capital social de la

Société,

* un montant de vingt-trois mille cinquante-sept livres sterling et soixante-dix pence (GBP 23.057,70) doit être alloué

au compte de prime d’émission de la Société connecté aux MGT MRPS de la Société, et

* un montant de mille sept cent dix livres sterling et trente-deux pence (GBP 1.710,32) doit être alloué au compte de

prime d’émission général des MRPS de la Société.

Il a été prouvé par un certificat émis par le Certificat 11 que:
«Robin Anderson est le propriétaire des PECs Contribués 11;
à la date du certificat, la valeur comptable des PECs Contribués 11 était de vingt-quatre mille sept cent soixante-dix

livres sterling et quarante-deux pence (GBP 24.770,42); et

les PECs Contribués 11 sont contribuées par Robin Anderson à la Société en échange de l’émission par la Société de

deux cent quarante (240) MGT MRPS sous forme nominative, ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune.»

12. Nicholas Jackson, land &amp; planning director, né le 22 mars 1954 à Derby, Royaume-Uni, résidant au 6 Harvest Place,

School Hill, Wargrave, Berkshire, RG10 8AQ, Royaume-Uni, ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO
CONDE, employée privée, demeurant professionnellement à Esch/Alzette, en vertu d’une procuration donnée sous seing
privé, déclare souscrire à:

- trois cent (300) Parts Sociales BB1, ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune;
trois cent (300) Parts Sociales BB2, ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune;
trois cent (300) Parts Sociales BB3, ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune;

95220

L

U X E M B O U R G

trois cent (300) Parts Sociales BB4, ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune; et
trois cent (300) Parts Sociales BB5, ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune;
et de les libérer entièrement par voie de contribution en numéraire d’un montant total de six mille livres sterling (GBP

6.000), qui doit être alloué comme suit:

* un montant de quinze livres sterling (GBP 15) doit être alloué au compte du capital social de la Société, et
* un montant de cinq mille neuf cent quatre-vingt-cinq livres sterling (GBP 5.985) doit être alloué au compte de prime

d’émission de la Société connecté aux parts sociales ordinaire de classe BB de la Société.

Le Certificat 1, le Certificat 2, le Certificat 3, le Certificat 4, le Certificat 5, le Certificat 6, le Certificat 7, le Certificat

8, le Certificat 9, le Certificat 10 et le Certificat 11, après avoir été signés "ne varietur" par le mandataire des parties
comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte pour les formalités de l’enregistrement.

Le montant total de dix-huit mille livres sterling (GBP 18.000) est immédiatement à la libre disposition de la Société,

dont la preuve a été apportée au notaire instrumentant.

Les Associés, David Simpson, Paul Beaney, Jonathan Cranley, Paul Wills, Marc Taylor, Greg Meier, David Chandler,

Ian Haggerty, Richard Milton, Lee Gardner et Robin Anderson, représentant désormais l’entièreté du capital social de la
Société et constituent l’Assemblée, ont unanimement décident d’adopter les résolutions suivantes:

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide de modifier le registre des associés de la Société afin de refléter l’augmentation du capital social

ci-dessus et de donner pouvoir et autorité à tout gérant de la Société, chacun individuellement, pour procéder, pour le
compte de la Société, à l’enregistrement des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée décide de modifier l’article 5.1. des Statuts, lequel aura désormais la teneur suivante:

« 5.1. Le capital social de la Société est fixé à quarante-trois mille six cent quarante-cinq livres sterling et treize pence

(GBP 43.645,13) représenté par (i) cent trente mille deux cents (130.200) parts sociales ordinaires de classe A1 (les Parts
Sociales A1), (ii) cent trente mille deux cents (130.200) parts sociales ordinaires de classe A2 (les Parts Sociales A2), (iii)
cent trente mille deux cents (130.200) parts sociales ordinaires de classe A3 (les Parts Sociales A3), (iv) cent trente mille
deux cents (130.200) parts sociales ordinaires de classe A4 (les Parts Sociales A4), (v) cent trente mille deux cents
(130.200) parts sociales ordinaires de classe A5 (les Parts Sociales A5, avec les Parts Sociales A1, les Parts Sociales A2,
les Parts Sociales A3 et les Parts Sociales A4, les Parts Sociales Ordinaires A), (vi) vingt-sept mille quatre-vingt-dix-neuf
(27.099)  parts  sociales  ordinaires  de  classe  AA1  (les  Parts  Sociales  AA1),  (vii)  vingt-sept  mille  quatre-vingt-dix-neuf
(27.099)  parts  sociales  ordinaires  de  classe  AA2  (les  Parts  Sociales  AA2),  (viii)  vingt-sept  mille  quatre-vingt-dix-neuf
(27.099)  parts  sociales  ordinaires  de  classe  AA3  (les  Parts  Sociales  AA3),  (ix)  vingt-sept  mille  quatre-vingt-dix-neuf
(27.099) parts sociales ordinaires de classe AA4 (les Parts Sociales AA4), (x) vingt-sept mille cent (27.100) parts sociales
ordinaires de classe AA5 (les Parts Sociales AA5, avec les Parts Sociales AA1, les Parts Sociales AA2, les Parts Sociales
AA3 et les Parts Sociales AA4, les Parts Sociales Ordinaires AA), (xi) neuf mille quatre-vingt-quinze (9.095) parts sociales
ordinaires de classe B1 (les Parts Sociales B1), (xii) neuf mille quatre-vingt-quinze (9.095) parts sociales ordinaires de
classe B2 (les Parts Sociales B2), (xiii) neuf mille quatre-vingt-quinze (9.095) parts sociales ordinaires de classe B3 (les
Parts Sociales B3), (xiv) neuf mille quatre-vingt-seize (9.096) parts sociales ordinaires de classe B4 (les Parts Sociales B4),
(xv) neuf mille quatre-vingt-seize (9.096) parts sociales ordinaires de classe B5 (les Parts Sociales B5, avec les Parts Sociales
B1, les Parts Sociales B2, les Parts Sociales B3 et les Parts Sociales B4, les Parts Sociales Ordinaires B), (xvi) mille trois
cents (1.300) parts sociales ordinaires de classe BB1 (les Parts Sociales BB1), (xvii) mille trois cents (1.300) parts sociales
ordinaires de classe BB2 (les Parts Sociales BB2), (xviii) mille trois cents (1.300) parts sociales ordinaires de classe BB3
(les Parts Sociales BB3), (xix) mille trois cents (1.300) parts sociales ordinaires de classe BB4 (les Parts Sociales BB4), (xx)
mille trois cents (1.300) parts sociales ordinaires de classe BB5 (les Parts Sociales BB5, avec les Parts Sociales BB1, les
Parts Sociales BB2, les Parts Sociales BB3 et les Parts Sociales BB4, les Parts Sociales Ordinaires BB), (xxi) six cent quatre-
vingt mille cinq cent quatre-vingt-quatorze (680.594) parts sociales ordinaires de classe C (les Parts Sociales C), (xxii)
une (1) part sociale ordinaire de classe D (la Part Sociale Ordinaire D, avec les Parts Sociales Ordinaires A, les Parts
Sociales Ordinaires AA, les Parts Sociales Ordinaires B, les Parts Sociales Ordinaires BB et les Parts Sociales Ordinaires
C, les Parts Sociales Ordinaires), (xxiii) deux million soixante-quatorze mille quarante-neuf (2.074.049) parts sociales
privilégiées obligatoirement rachetables OCM (les OCM MRPS), (xxiv) cent quatre-vingt-quatorze mille six cent quatre-
vingt-onze (194.691) parts sociales privilégiées obligatoirement rachetables CHY (les CHY MRPS), (xxv) trente-et-un
mille deux cent quatre-vingt-dix (31.290) parts sociales privilégiées obligatoirement rachetables MGT (les MGT MRPS)
et (xxvi) cinq cent quarante-cinq mille quatre cent soixante-cinq (545.465) parts sociales privilégiées obligatoirement
rachetables FEI (les FEI MRPS), sous forme nominative, ayant une valeur nominale d’un penny (GBP 0,01) chacune, toutes
souscrites et entièrement libérées.

Les détenteurs des parts sociales émises par la Société, peu importe leur classe, sont ensemble désignées les Associés,

et individuellement un Associé.»

95221

L

U X E M B O U R G

<i>Sixième résolution

L’Assemblée décide de nommer PricewaterhouseCoopers LLP, un limited liability partnership anglais, immatriculée en

Angleterre sous le numéro OC303525, avec siège social au 1 Embankment Place, London WC2N 6RH, Royaume-Uni,
en qualité de commissaire aux comptes de la Société de la date de la présente assemblée à l’assemblée générale annuelle
de 2015.

Plus aucun point ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Estimation des frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte est estimé à environ trois mille cinq cents euros (EUR
3.500,-).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le

présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française et en cas de divergences entre la version anglaise et
française, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, rédigé et passé à Esch/Alzette, à la date indiquée en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, ce mandataire a signé avec le notaire instrumentant le

présent acte original.

Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 13 février 2014. Relation: EAC/2014/2249. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2014074047/1462.
(140087284) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.

ASCENSEURS Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3390 Peppange, 64, route de Crauthem.

R.C.S. Luxembourg B 88.234.

<i>Extrait du Procès-verbal de l'assemblée Générale des actionnaires du 19 août 2013

<i>Délibérations et décisions

1. Démission des administrateurs de la Société
L'assemblée générale prend connaissance et accepte les démissions de Monsieur Jean Pierre Schellings et de Monsieur

Alberto Goñi, en tant qu'administrateur de la Société.

2. Nomination des administrateurs de la Société
L'assemblée générale décide de nommer les personnes suivantes en tant qu'administrateurs de la Société pour un

période de six ans:

- Monsieur Aitor Mendia Azkue, domicilié Calle Moreaga, 2 - 2B, ES-48640 Berango (Vizcaya) Espagne.
- Monsieur Garikoitz Garcia Castellanos, domicilié 4, rue des Girondins L-1626 Luxembourg.
Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2019
A partir de ce jour, le conseil d'administration est composé comme suit:
- Monsieur Francisco Javier Mutuverria; et
- Monsieur Aitor Mendia Azkue; et
- Monsieur Garikoitz Garcia Castellanos.
3. Démission de l'administrateur délégué de la Société
Le conseil d'administration prend connaissance de et accepte la démission de Monsieur Jean Pierre Schellings en tant

qu'administrateur délégué de la Société.

4. Nomination d'un administrateur délégué de la Société
Le conseil d'administration décide de nommer Monsieur Garikoitz Garcia Castellanos, domicilié 4, rue des Girondins

L-1626 Luxembourg, en tant qu'administrateur délégué de la Société. Son mandat d'administrateur délégué prendra fin à
l'expiration de son mandat d'administrateur de la Société.

Conformément à l'article 9 des statuts, la Société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de

deux administrateurs dont celle de l'administrateur délégué, ou par la signature de l' administrateur-délégué, sans préjudice
des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégations de pouvoir et de mandats conférés par le conseil
d'administration.

95222

L

U X E M B O U R G

L'ordre du jour de la présente réunion du conseil d'administration étant épuisé, celle-ci est clôturée après la signature

du procès-verbal par les administrateurs.

M. MUTUVERRIA Francisco Javier / M. MENDIA AZKUE Aitor.

Référence de publication: 2014073544/36.
(140086828) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.

BMO Finance Company I, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 160.239.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-ninth day of April,
Before Maître Jean SECKLER, civil law notary residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held

an extraordinary general meeting of the sole shareholder of BMO Finance Company I, a Luxembourg société à res-

ponsabilité limitée (private limited liability company), with a share capital of USD 3,620,014, having its registered office at
9, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2, L-5365 Munsbach, Grand-Duchy of Luxembourg and registered with
the Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg (Trade and Companies Register) under number B 160.239.

There appeared:

Bank of Montreal, a corporation duly incorporated and validly existing as a chartered bank under the Bank Act (Canada),

having its head office at 129 rue Saint Jacques Montreal, Quebec, Canada H2Y 1L6 and its executive offices at 100 King
Street West, 1 First Canadian Place, Toronto, Ontario Canada M5X 1A1 (the “Sole Shareholder”);

here represented by Mr Max MAYER, employee, residing professionally in Junglinster, 3, route de Luxembourg, Grand-

Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney.

The said proxy, initialed ne varietur shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The:
- 595,014 class A mandatory redeemable preferred shares with a nominal value of USD 1 each (the “Class A MRPS”);
- 3,000,000 class B ordinary shares with a nominal value of USD 1 each (the “Class B Ordinary Shares”); and
- 25,000 class C ordinary shares with a nominal value of USD 1 each (the “Class C Ordinary Shares”);
representing the whole share capital of the Company are represented so that the meeting can validly decide on all the

items of the agenda of which the Sole Shareholder has been duly informed.

The Sole Shareholder requests the notary to enact that the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1. First decrease of the share capital of the Company by way of the redemption and cancellation of all the Class A

MRPS;

2. Second decrease of the share capital of the Company by way of the redemption and cancellation of all the Class B

Ordinary Shares;

3. Subsequent amendment of article 6 of the articles of association of the Company in order to reflect the decrease

of the share capital of the Company; and

4. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolutions have been taken:

<i>First resolution

It is resolved to:
(i) decrease the share capital of the Company by an amount of USD 595,014 (five hundred ninety-five thousand and

fourteen US Dollars) so as to reduce it from its current amount of USD 3,620,014 (three million six hundred twenty
thousand and fourteen US Dollars) to USD 3,025,000 (three million and twenty-five thousand US Dollars) by the re-
demption and subsequent cancellation of 595,014 (five hundred ninety-five thousand and fourteen) Class A MRPS and all
rights attached thereto in accordance with article 10 of its articles of association;

(ii) to approve the Class A MRPS redemption price as determined by the board of managers of the Company in

accordance with article 10 of the articles of association of the Company at an amount of USD 595,014,000 (five hundred
ninety-five million and fourteen thousand US Dollars); and

(iii) all the conditions of article 10 of the articles of association of the Company being met, to redeem all the 595,014

(five hundred ninety-five thousand and fourteen) Class A MRPS with a nominal value of USD 1 each and to reimburse the
Sole Shareholder of an amount of an amount of USD 595,014,000 (five hundred ninety-five million and fourteen thousand
US Dollars), followed by the cancellation of all the Class A MRPS.

95223

L

U X E M B O U R G

<i>Second resolution

It is resolved to:
(i) decrease the share capital of the Company by an amount of USD 3,000,000 (three million US Dollars) so as to

reduce it from its current amount of USD 3,025,000 (three million and twenty-five thousand US Dollars) to USD 25,000
(twenty-five thousand US Dollars) by the redemption and subsequent cancellation of 3,000,000 (three million) Class B
Ordinary Shares and all rights attached thereto in accordance with article 10 of its articles of association;

(ii) to approve the Class B Ordinary Shares redemption price as determined by the board of managers of the Company

in accordance with article 10 of the articles of association of the Company at an amount of USD 3,000,000 (three million
US Dollars) corresponding to the aggregate amount of nominal value of the 3,000,000 (three million) redeemed Class B
Ordinary Shares;

(iii) all the conditions of article 10 of the articles of association of the Company being met, to redeem all the 3,000,000

(three million) Class B Ordinary Shares with a nominal value of USD 1 each and to reimburse the Sole Shareholder of
an amount of USD 3,000,000 (three million US Dollars), followed by the cancellation of all the Class B Ordinary Shares.

<i>Third resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, it is resolved to amend article 6 of the articles of association of the

Company to read as follows:

“ Art. 6. Capital. The Company's share capital is set at USD 25,000 (twenty-five thousand US Dollars) divided into

25,000 (twenty-five thousand) class C ordinary shares (the „Class C Ordinary Shares“.);

Each Class C Ordinary Shares is issued with a nominal value of USD 1 (one US Dollar).
The share capital may be increased or reduced from time to time by a resolution of the sole shareholder, or in case

of plurality of shareholders, by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders representing at least
seventy-five percent (75%) of the share capital.

<i>Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its capital decreases, have been estimated at about EUR 2,200.-.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, they signed together with us, the notary, and the present

original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le vingt-neuvième jour d'avril,
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

Se réunit

une assemblée générale extraordinaire de l'associé de la société à responsabilité limitée luxembourgeoise BMO Finance

Company I, une société à responsabilité limitée valablement constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de
Luxembourg, avec un capital social d'un montant de 3,620,014 USD, ayant son siège social au 9, rue Gabriel Lippmann,
Parc d'Activité Syrdall 2, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 160.239 (la «Société»).

A comparu:

Bank of Montreal, une société dûment constituée et existant valablement selon le Bank Act (Canada), ayant son siège

social au 129 rue Saint Jacques Montréal, Québec, Canada H2Y 1L6 et son adresse principale au 100 King Street West,
1 First Canadian Place, Toronto, Ontario Canada M5X 1A1 (l'«Associé Unique»);

ici représentée par Monsieur Max MAYER, employé, résidant professionnellement à Junglinster, 3, route de Luxem-

bourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par la partie comparante et le notaire instrumentant, restera

annexée au présent acte aux fins d'enregistrement.

Les:
- 595.014 parts sociales préférentielles à rachat obligatoire de classe A (les «MRPS de Classe A»);
- 3.000.000 parts sociales ordinaires de classe B (les «Parts Sociales Ordinaires de Classe B»); et
- 25.000 parts sociales ordinaires de classe C (les «Parts Sociales Ordinaires de Classe C»);

95224

L

U X E M B O U R G

représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut décider

valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont l'Associé Unique a été dûment informé.

L'Associé Unique, prie le notaire d'acter que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Première réduction du capital social de la Société par le rachat et l'annulation des MRPS de Classe A;
2. Deuxième réduction du capital social de la Société par le rachat et l'annulation des Parts Sociales Ordinaires de

Classe B;

3. Modification subséquente de l'article 6 des statuts de la Société; et
4. Divers.
Après que l'agenda eut été approuvé par l'Associé Unique, les résolutions suivantes ont été prises:

<i>Première résolution

Il est décidé de:
(i) réduire le capital social de la Société à concurrence d'un montant de 595.014 USD (cinq cent quatre-vingt-quinze

mille quatorze Dollars américains), pour le porter de son montant actuel de 3.620.014 USD (trois millions six cent vingt
mille quatorze Dollars américains) à 3.025.000 USD (trois millions vingt-cinq mille Dollars américains) par le rachat et
l'annulation subséquente de 595.014 (cinq cent quatre-vingt-quinze mille quatorze) MRPS de Classe A et de tous droits
y attachés en conformité avec l'article 10 des statuts de la Société;

(ii) approuver le prix de rachat des MRPS de Classe A déterminé par le conseil de gérance de la Société conformément

à l'article 10 des statuts de la Société à un montant de 595,014,000 USD (cinq cent quatre-vingt-quinze millions quatorze
mille Dollars américains);

(iii) toutes les conditions de l'article 10 des statuts de la Société étant réunies, il est décidé de racheter les 595.014

(cinq cent quatre-vingt-quinze mille quatorze) MRPS de Classe A d'une valeur nominale de 1 USD chacune et de rem-
bourser l'Associé Unique d'un montant de 595,014,000 USD (cinq cent quatre-vingt-quinze millions quatorze mille Dollars
américains) et en conséquence d'annuler les MRPS de Classe A.

<i>Deuxième résolution

Il est décidé de:
(i) réduire le capital social de la Société à concurrence d'un montant de 3.000.000 USD (trois million Dollars améri-

cains), pour le porter de son montant actuel de 3.025.000 USD (trois millions vingt-cinq mille Dollars américains) à 25.000
USD (vingt-cinq mille Dollars américains) par le rachat et l'annulation subséquente de 3.000.000 (trois million) de MRPS
de Classe A et de tous droits y attachés en conformité avec l'article 10 des statuts de la Société;

(ii) approuver le prix de rachat des Parts Sociales Ordinaires de Classe B déterminé par le conseil de gérance de la

Société conformément à l'article 10 des statuts de la Société à un montant de 3.000.000 USD (trois million de Dollars
américains) correspondant au montant total de la valeur nominale des 3.000.000 (trois million) de Parts Sociales Ordi-
naires de Classe B rachetées;

(iii) toutes les conditions de l'article 10 des statuts de la Société étant réunies, il est décidé de racheter les 3.000.000

(trois million) de Parts Sociales Ordinaires de Classe B d'une valeur nominale de 1 USD chacune et de rembourser
l'Associé Unique d'un montant de 3.000.000 USD (trois millions Dollars américains) et en conséquence d'annuler les
Parts Sociales Ordinaires de Classe B.

<i>Troisième résolution

En conséquence des déclarations et résolutions qui précèdent il a été a décidé de modifier l'article 6 des statuts de la

Société comme suit:

« Art. 6. Capital. Le capital social de la Société est fixé à 25.000 USD (vingt-cinq mille Dollars américains) divisé en

25.000 (vingt-cinq mille) parts sociales ordinaires de classe C (les «Parts Sociales Ordinaires de Classe C»);

Chaque Part Sociale de Classe C est émise avec une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain).
Le capital social peut être augmenté ou réduit par résolution de l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, par

résolution prise par un vote de la majorité des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital
social de la Société.»

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, honoraires ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou

qui sont mis à sa charge en raison des réductions de son capital, s'élève à environ 2.200,- EUR.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire instrumentant qui comprend et parle anglais acte par la présente qu'à la demande des comparants, le présent

acte est rédigé en anglais suivi par une traduction française. A la demande des mêmes personnes et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

95225

L

U X E M B O U R G

DONT ACTE, passé à Junglinster, le jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec nous, notaire, le présent acte.
Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 06 mai 2014. Relation GRE/2014/1803. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME

Junglinster, le 26 mai 2014.

Référence de publication: 2014073593/165.
(140087115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.

Coni, Société en Commandite spéciale.

Siège social: L-8240 Mamer, 5, rue Raoul Follereau.

R.C.S. Luxembourg B 186.970.

<i>Extract of the memorandum of association in the form of a private deed for the special limited partnership

<i>Annule et remplace la 1° version déposée le 15.05.2014 sous le n° L140080107

1. A Special Limited Company was formed (hereafter the Company) on 13/05/2014.
2. The name of the Company is “CONI”.
3. Designation of the General Partners:
a) The company TITRAGEST Sàrl, incorporated on 8/09/2004, with registered office at 5, Rue Raoul Follereau, L-8240

Mamer-Capellen, Grand Duchy of Luxemboug registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under
the number B-103363, represented by its permanent representative, Mr Benoit de BIEN, born 29/01/1935, Etterbeek,
Belgium

b) Anne Mellentin, 22 Musgrave Crescent, SW64QE London, United Kingdom, née le 31/07/1969
4.  The  sole  object  of  the  Company  is  to  hold  financial  instruments,  participations,  hold  or  grant  loans,  bonds  or

advances, intellectual properties, real estate, or any other tangible or intangible assets. The Company may issue any type
of debt instrument to finance its object. The Company may undertake any inspection, supervision and documentation
measures and carry out any transaction that it may deem useful for the accomplishment of its object.

5. The registered office of the Company is established in Mamer/Capellen at the following address: 5, Rue Raoul

Follereau, L-8240 Mamer- Capellen

6. The Company is formed for an unlimited duration. It shall not be dissolved by the death, incapacity, suspension,

bankruptcy or ruin of a Partner. The General Partner may decide, however, at any time to dissolve the Company. The
Limited Partner(s) cannot decide or vote to terminate the Company if the General Partner opposes to.

7. The company is managed jointly by the General Partners: TITRAGEST Sarl (Luxembourg Trade and Companies

Register number B-103363), represented by its permanent representative, Mr Benoit de BIEN, born 29/01/1935, Etter-
beek, Belgium) and Anne Mellentin, 22 Musgrave Crescent, SW64QE London, United Kingdom, née le 31/07/1969

Suit la version en langue française du texte qui précède:

<i>Annule et remplace la 1° version déposée le 15.05.2014 sous le n° L140080107

<i>Extrait des statuts de la société en commandite spéciale

1. Il a été constitué en date du 13/05/2014 une société en commandite spéciale (ci après la Société)
2. La dénomination de la Société est «CONI»
3. Désignation des l’associés commandités:
a) TITRAGEST Sàrl, constituée le 8/09/2004, avec siège à 5, Rue Raoul Follereau, L-8240 Mamer-Capellen, Grand

Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de commerce et des sociétés sous le numéro B-103363, repré-
sentée par son représentant permanent, Mr Benoit de BIEN, né le 29/1/1935 à Etterbeek, Belgique.

b) Anne Mellentin, 22 Musgrave Crescent, SW64QE London, United Kingdom, née le 31/07/1969
4. L’objet de la Société est de détenir des instruments financiers, des participations, détenir ou consentir des prêts,

des emprunts obligataires ou des avances, des droits intellectuels, de l’immobilier ou tout type d’actifs mobilier ou in-
corporel. La Société peut émettre n’importe quel type d’instrument de dette pour financer son objet social.

La Société peut prendre toutes mesures de contrôle, de surveillance et de documentation et faire toutes opérations

qu'elle jugera utiles à l’accomplissement de son objet social.

5. Le siège social est établi à Mamer/Capellen, à l’adresse suivante:
5, Rue Raoul Follereau, L-8240 Mamer- Capellen

95226

L

U X E M B O U R G

6. La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle ne sera pas dissoute par la mort, l’incapacité, l’interdiction,

la faillite ou la déconfiture d’un des associés. Cependant l’associé commandité peut décider à tout moment de dissoudre
la Société. Les associés commanditaires ne peuvent décider ou voter en faveur de la clôture de la Société si l’associé
commandité s’y oppose.

7. La Société est gérée conjointement par les associés commandités: TITRAGEST Sarl (Registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg numéro B-103363), représentée par son représentant permanent, Mr Benoit de BIEN, né le
29/1/1935 à Etterbeek, Belgique and Anne Mellentin, 22 Musgrave Crescent, SW64QE London, United Kingdom, née le
31/07/1969

Mamer, le 13 mai 2014.

Référence de publication: 2014073661/55.
(140087089) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.

EsDé Immobilier S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-1320 Luxembourg, 53, rue de Cessange.

R.C.S. Luxembourg E 5.155.

L’an deux mille quatorze, le neuf mai.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg,

ont comparu:

1) Monsieur Paul SCHOLTES, demeurant à L-1320 Luxembourg, 53, rue de Cessange, né à Luxembourg le 9 novembre

1960 (matricule no 19601109150) et son épouse;

2) Madame Marianne DUHR, demeurant à L-1320 Luxembourg, 53, rue de Cessange, née à La Haye (NL), le 30 mars

1962 (matricule no 19620330143).

Lesquels ont exposé au soussigné notaire et l’ont requis d’acter:
A.- Qu’ils sont les seuls associés de la société civile immobilière «EsDé Immobilier S.C.I.», ayant son siège social à

Luxembourg, constituée suivant acte sous seing privé, en date du 10 septembre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations C numéro 2658 du 24 octobre 2013, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro E 5155 (matricule n°2013 7002095).

B.- Qu’ils déclarent vouloir se réunir en assemblée générale extraordinaire pour faire apport à la société de deux

appartements situés à Luxembourg-Gasperich et à Luxembourg-Kirchberg, leur appartenant à chacun pour une moitié
(1/2) indivise.

Ceci exposé, les comparants, agissant ès-qualités, ont déclaré se réunir à l’instant même en assemblée générale ex-

traordinaire et ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés décident d’augmenter le capital social d’un montant de EUR 351.672.- (trois cent cinquante-et-un mille

six cent soixante-douze euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 10.000.- (dix mille euros) à EUR 361.672.-
(trois cent soixante-et-un mille six cent soixante-douze euros) par la création de 351.672 (trois cent cinquante-et-un
mille six cent soixante-douze) parts nouvelles d’une valeur nominale de EUR 1.- (un euro) chacune.

<i>Souscription et libération

Les comparants prémentionnés déclarent souscrire les nouvelles parts comme suit:

Monsieur Paul SCHOLTES, prénommé :
Cent soixante-quinze mille huit cent trente-six parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175.836
Madame Marianne DUHR, prénommée :
Cent soixante-quinze mille huit cent trente-six parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175.836

En libération des parts nouvelles ainsi souscrites, les comparants déclarent faire apport en nature à la société des droits

immobiliers ci-après désignés:

<i>Désignation

I. - Dans un immeuble en copropriété sis à Luxembourg-Gasperich, 2, rue Henri Pensis, dénommé «Résidence Hor-

tense», inscrit au cadastre comme suit:

Commune de la Ville de Luxembourg, ancienne commune de Hollerich, section HoC de Gasperich
Numéro cadastral 83/1947, lieu-dit «rue Henri Pensis», maison-place, contenant 13 ares 70 centiares,
a) en propriété privative et exclusive:

95227

L

U X E M B O U R G

- le STUDIO numéro 14-III au troisième étage, correspondant à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,691/1000
- la CAVE numéro 1 au sous-sol, correspondant à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,134/1000

- le GARAGE numéro 7 au rez-de-chaussée, correspondant à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,940/1000

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,765/1000

b) en copropriété et indivision forcée:
une quotité de TRENTE-CINQ virgule SEPT CENT SOIXANTE-CINQ millièmes des parties communes, dont le sol

ou terrain.

Tels que plus amplement désignés dans un acte de base avec règlement général de copropriété reçu par le notaire

Carlo Funck, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20 mai 1974, transcrit au premier bureau des hypo-
thèques à Luxembourg le 21 juin 1974, volume 622, numéro 49.

L’immeuble ainsi apporté est évalué par les comparants à EUR 170.232.- (cent soixante-dix mille deux cent trente-

deux euros).

II. - Dans un immeuble en copropriété sis à Luxembourg, 24, rue Mathias Tresch, inscrit au cadastre comme suit:
Commune de la Ville de Luxembourg, ancienne commune d’Eich, section EC de Weimerskirch
Numéro cadastral 890/4900, lieu-dit «rue Mathias Tresch, place (occupée)-bâtiment à habitation, contenant 49,80 ares,
A. / Un droit de superficie sur
a) en propriété privative et exclusive:
Le lot numéro 1, soit l’APPARTEMENT A.0.1. sis au rez-de-chaussée, à gauche, la CAVE 1 sise au sous-sol et une

parcelle de JARDIN, faisant

b) en copropriété et indivision forcée:
une quotité de QUINZE virgule QUATRE-VINGT-DIX-HUIT millièmes (15,98/1000) des parties communes.
B. / Un droit d’emphytéose sur
une quotité de QUINZE virgule QUATRE-VINGT-DIX-HUIT millièmes (15,98/1000) du terrain sur lequel l’immeuble

en copropriété se trouve érigé, avec tous ses aménagements.

Tels que plus amplement désignés dans un acte de base avec règlement général de copropriété reçu par le notaire

Tom Metzler, alors notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 13 décembre 1988, transcrit au premier
bureau des hypothèques à Luxembourg le 5 janvier 1989, volume 1147, numéro 43.

L’immeuble ainsi apporté est évalué par les comparants à EUR 181.440.- (cent quatre-vingt-un mille quatre cent qua-

rante euros).

<i>Origine de propriété

L’immeuble pré-désigné sub I. a été acquis par les époux Paul Scholtes-Duhr sur les époux Gérard Schmit-Koepp aux

termes d’un acte de vente, reçu par le notaire Jean-Paul Hencks, alors de résidence à Luxembourg, en date du 22 juin
2001, transcrit au premier Bureau des Hypothèques à Luxembourg le 20 juillet 2001, volume 1692, numéro 145.

L’immeuble pré-désigné sub II. a été acquis par les époux Paul Scholtes-Duhr sur Monsieur Janos Nadasi aux termes

d’un acte de vente, reçu par le notaire Tom Metzler, prénommé, en date du 15 mars 1999, transcrit au premier Bureau
des Hypothèques à Luxembourg le 20 avril 1999, volume 1585, numéro 83.

<i>Clauses et conditions de l’apport

L’apport immobilier ci-dessus se fait encore aux clauses et conditions suivantes:
1.- Les immeubles sont apportés tels et ainsi qu’ils se trouvent et se comportent actuellement, avec toutes leurs

appartenances et dépendances ainsi qu’avec toutes les servitudes actives et passives, occultes et apparentes, continues
et discontinues pouvant y être attachées, sauf à la société de faire valoir les unes et se défendre des autres, mais à ses
frais, risques et périls et sans recours contre les apporteurs. Les apporteurs déclarent qu’ils n’ont personnellement créé
aucune servitude et qu’il n’est pas à leur connaissance qu’il en existe une à charge des immeubles pré-désignés.

2.- Il n’y aura de part et d’autre ni garantie ni répétition, pour raison soit de vices, de mitoyenneté et de dégradations

quelconques, même cachés, soit pour erreur dans la désignation cadastrale ou pour différence de contenance; une telle
différence en plus ou moins excédât-elle un vingtième, fera profit ou perte à la société.

3.- La société aura la propriété et la jouissance des immeubles lui apportés à compter de ce jour, à charge d’en payer

et supporter à partir de ce jour tous impôts, taxes et contributions quelconques.

4.- Les apporteurs déclarent que les objets de l’apport ne sont grevés d’aucun droit de préemption au profit d’un tiers.
5.- Il est certifié par les apporteurs que les immeubles pré-désignés sont libres de toutes charges privilégiées et hypo-

thécaires.

6.-  Les  immeubles  où  se  situent  les  objets  apportés  à  la  société  en  vertu  des  présentes,  tout  comme  les  prédits

règlements, comprenant notamment le statut des immeubles et les tableaux des millièmes, tombent sous les dispositions
de la loi du 16 mai 1975 et du 22 avril 1985, ainsi que du règlement grand-ducal du 13 juin 1975, portant statut de la
copropriété des immeubles bâtis, ce dont les comparants ont déclaré avoir parfaite connaissance, de même que des

95228

L

U X E M B O U R G

règlements de copropriété ci-avant relevés. Ils s’engagent à notifier le transfert de propriété aux syndics respectifs et à
faire dresser un décompte relativement aux charges communes de la copropriété.

Les comparants, pris en leurs qualités de gérants de la société «EsDé Immobilier S.C.I.», s’engagent à l’accomplissement

de toutes les formalités et modalités en relation avec l’apport immobilier qui précède.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l’article 6 des statuts est modifié comme suit:

« Art. 6. Le capital social de la société est fixé à EUR 361.672.- (trois cent soixante-et-un mille six cent soixante-douze

euros). Il est représenté par 361.672 (trois cent soixante-et-un mille six cent soixante-douze) parts d’une valeur nominale
de EUR 1.- (un euro) chacune.»

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de la présente augmentation de son capital, est estimé sans nul préjudice à la somme
de EUR 6.500.-.

Dont acte , fait et dressé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture de tout ce qui précède aux comparants, connus du notaire instrumentant par noms, prénoms usuels,

états et demeures, ils ont tous signé le présent procès-verbal avec le notaire, lequel certifie l’état civil des comparants,
conformément aux dispositions de la loi du 26 juin 1953, sur base d’extraits des registres de l’état civil.

Signé: P. SCHOLTES, M. DUHR et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 15 mai 2014. Relation: LAC/2014/22650. Reçu soixante-quinze euros 351.672,00 €

à 0,50% = 1.758,36 € / + 2/10 = 351,67 € / 2.110,03 €.

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 26 mai 2014.

Référence de publication: 2014073709/121.
(140086964) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.

Global Sporting Rights Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 64.860.000,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 163.963.

<i>Extrait de l'assemblée générale annuelle des Associés de la Société en date du 20 mai 2014

- Les associés ont accepté la démission de Halsey S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant un capital social de EUR

12.500,-, ayant son siège social au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 50984, de son poste de gérant de la Société, avec effet
immédiat;

- Les associés ont nommé avec effet immédiat M. Davy Beaucé, né le 30 décembre 1981, à Messancy, Belgique, ayant

son adresse professionnelle au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg en tant que gérant de la Société pour
une durée indéterminée;

Par conséquent, les gérants de la Société au 20 mai 2014 sont les suivants:
- Charles Barter;
- Paul Gunner;
- Daphné Charbonnet;
- Christophe Gammal;
- Michaël Goosse; et
- Davy Beaucé.
L'associé de la Société, CS Stratégie Partners V VC Holdings, LP, a décidé de (i) changer sa dénomination en Strategic

Partners V VC Holdings, LP et (ii) transféré son siège social qui est désormais au 345 Park Avenue, 10154 New York,
NY, Etats-Unis d'Amérique.

Il y a dorénavant lieu de prendre en compte l'adresse professionnelle de Messieurs Charles Barter et Paul Gunner,

gérants de la Société, située au 95, Wigmore Street, Londres W1U 1FB, Royaume-Uni.

95229

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 mai 2014.

Signature.

Référence de publication: 2014073775/30.
(140087069) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.

Switex S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 9.988.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 9 mai 2014 à 15.00 heures à Luxembourg

- L'Assemblée décide à l'unanimité de renouveler le mandat d'Administrateur de:
Joseph WINANDY
Koen LOZIE
JALYNE SA., représentée par Jacques BONNIER
pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes annuels

arrêtés au 31 décembre 2014.

- L'Assemblée décide à l'unanimité de renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes de:
Monsieur Pierre SCHILL
pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes annuels

arrêtés au 31 décembre 2014.

Pour copie conforme
K. LOZIE / J. WINANDY
<i>Administrateur / Président

Référence de publication: 2014073338/21.
(140085666) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2014.

Spaniba S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 22.162.500,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 128.694.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SPANIBA S. à r.l.

Référence de publication: 2014073331/10.
(140085339) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2014.

UBS (Lux) Money Market Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 86.004.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale annuelle du 22 avril 2014

Sont réélus au conseil d'administration:
M. Thomas Rose
président et membre du conseil d'administration
Stockerstrasse, 64, CH-8002 Zurich, Suisse
jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2016
M. Aloyse Hemmen
membre du conseil d'administration
33A Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg
jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2017
M. Michael Kehl
membre du conseil d'administration
Stockerstrasse, 64, CH-8002 Zurich, Suisse

95230

L

U X E M B O U R G

jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2015
M. Thomas Portmann
membre du conseil d'administration
Stockerstrasse, 64, CH-8002 Zurich,
Suisse jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2018
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour UBS (Lux) Money Market SICAV
UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Guillaume André / Mathias Welter
<i>Director / Associate Director

Référence de publication: 2014073387/30.
(140085549) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2014.

Vier Gas Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 100.000,00.

Siège social: L-1648 Luxembourg, 46, place Guillaume II.

R.C.S. Luxembourg B 168.600.

Les comptes consolidés au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 mai 2014.

Référence de publication: 2014073401/11.
(140085388) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2014.

UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 99.462.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale annuelle du 22 avril 2014

Sont réélus au conseil d'administration:
M. Robert Süttinger
président et membre du conseil d'administration
Stockerstrasse, 64, CH-8002 Zurich, Suisse
jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2016
M. Aloyse Hemmen
membre du conseil d'administration
33A Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg
jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2017
M. Michael Kehl
membre du conseil d'administration
Stockerstrasse, 64, CH-8002 Zurich, Suisse
jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2015
M. Thomas Portmann
membre du conseil d'administration
Stockerstrasse, 64, CH-8002 Zurich, Suisse
jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2018
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV
UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Guillaume André / Mathias Welter
<i>Director / Associate Director

Référence de publication: 2014073389/30.
(140085547) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2014.

95231

L

U X E M B O U R G

UBS (Lux) Institutional Sicav II, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 115.356.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale annuelle du 22 avril 2014

Sont réélus au conseil d'administration:
M. Tobias Meyer
président et membre du conseil d'administration
Aeschenplatz, 6, CH-4052 Basel, Suisse
jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2015
M. Aloyse Hemmen
membre du conseil d'administration
33A Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg
jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2016
M. Thomas Portmann
membre du conseil d'administration
Stockerstrasse, 64, CH-8002 Zurich, Suisse
jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2017
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour UBS (Lux) Institutional SICAV II
UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Guillaume André / Mathias Welter
<i>Director / Associate Director

Référence de publication: 2014073386/26.
(140085551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2014.

SPPR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 150.695.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014073332/10.
(140086063) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2014.

Weichai Power (Luxembourg) Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 100.000,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 173.173.

Avec effet au 1 

er

 Avril 2014, l'Associé Unique de la Société a pris la décision suivante:

- Démission de Mr. Liu Guangwei, de son poste de gérant avec effet immédiat;
- Nomination de Mr. Wu Guogang, né le 1 

er

 juillet 1978 à Hebei, Chine, ayant pour adresse professionnelle le 14

Floor, Tower D, Global Finance &amp; News Center, N°1 Xuanwumenwai Street, 100052, Beijing, République de Chine, au
poste de gérant pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

TMF Luxembourg S.A.
<i>Mandataire

Référence de publication: 2014073414/16.
(140085932) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2014.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

95232


Document Outline

ASCENSEURS Luxembourg S.A.

BMO Finance Company I

Coni

EsDé Immobilier S.C.I.

Global Sporting Rights Investments S.à r.l.

OCM Luxembourg Coppice Midco S.à r.l.

Roadexpress Sàrl

Smat's

Smat's

Socafe s.à r.l.

Société Générale Bank &amp; Trust

Société Générale Bank &amp; Trust

Sofidecor S.A.

Spaniba S.àr.l.

SPPR S.A.

Street Smart Société Civile

Switex S.A.

Sword Group SE

Sword Group SE

Taurus Investments S.à r.l.

Tele2 Finance Luxembourg S.A.

Telenetwork Luxembourg S.A.

Telenetwork Luxembourg S.A.

Telenetwork Luxembourg S.A.

Tempus Capital One GP S.à r.l.

Themis Realty Europe

TIAA Lux 5 S.à r.l.

Tishman Speyer Europe S.à r.l.

TMC Immo S.à r.l.

TMC Immo S.à r.l.

TMC Immo S.à r.l.

TOP Finanzbeteiligungs S.A.

Torrent Investments S.à r.l.

Transports Internationaux Wefa S.à.r.l.

Trasteel Investments Holding S.A.

Trasteel Investments Holding S.A.

Trasteel Trading Holding S.A.

TR S.A.

Turaz Global S.à r.l.

Turkey Juice Company S.à r.l.

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.

UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.

UBS (Lux) Institutional Sicav II

UBS (Lux) Institutional Sicav II

UBS (Lux) Money Market Sicav

UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav

UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav

Uncia S.A.

Urban Capital Lender 1 S.à r.l.

Urban Capital Lender 2 S.à r.l.

Usine du Nord S.à r.l.

Vallis Construction Sector Consolidation

Valon S.A.

Vier Gas Holdings S.à r.l.

Vizzion Participations, SCA

Weichai Power (Luxembourg) Holding S.à r.l.

Weiss Optik S.A.