This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1869
18 juillet 2014
SOMMAIRE
Aberro S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89676
ADEPA Asset Management S.A. . . . . . . . .
89668
Allianz Infrastructure Luxembourg Holdco
II S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89671
Allianz Infrastructure Luxembourg Holdco
I S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89668
D3fine S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89676
Dexia Luxpart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89666
DWS FlexPension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89667
DWS Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89676
DWS Institutional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89675
Feri Trust (Luxembourg) S.A. . . . . . . . . . . .
89674
FPM Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89676
Gresham Borehamwood IP S. à r.l. . . . . . .
89680
I-Space S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89686
Key Plastics Europe S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
89711
Largam S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89687
Laser International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
89711
Leoni-Els s.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89711
Luxembourg Contact Centers S.à r.l. . . . .
89687
LUX-EURO-Trade Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . .
89712
Luxtronique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89712
Monier Special Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . .
89712
Neunheuser S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89667
OAK International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
89699
Octave Investissement S.A. . . . . . . . . . . . . .
89675
Oneall Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89711
Payment Consultants S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
89680
PineBridge Alternative Investments Fund
SICAV-SIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89712
Quirk Capital S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89707
Rasec International Holding . . . . . . . . . . . . .
89666
Swiss Life Funds (Lux) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89707
Swiss Life Funds (Lux) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89699
Swiss Life Funds (Lux) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89703
Telpro Communications (Luxembourg)
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89703
Trilantic Events Management S.à r.l. . . . . .
89668
VCK Lease S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89687
Zencap Global S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89681
89665
L
U X E M B O U R G
Rasec International Holding, Société Anonyme.
Siège social: L-1643 Luxembourg, 4, rue de la Grève.
R.C.S. Luxembourg B 116.166.
Au nom du conseil d'administration de la société RASEC INTERNATIONAL HOLDING, société anonyme, ayant son
siège social au 4, rue de la Grève, L-1643 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 116.166, j'ai l'honneur de vous convoquer à une
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le <i>5 août 2014i> à Luxembourg au siège social de la Société à 11.30 heures, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Lecture des comptes consolidés au 31 décembre 2013;
2. Lecture du rapport du commissaire aux comptes concernant les comptes consolidés au 31 décembre 2013;
3. Lecture du rapport de gestion;
4. Approbation des comptes consolidés au 31 décembre 2013;
5. Délégation de pouvoir;
6. Divers.
<i>Possibilité d'assister à l'assemblée générale:
i>Toute personne dont le nom figure dans le registre des actions nominatives de la Société, ainsi que toute personne
détenant des actions au porteur de la Société peut assister à l'assemblée générale.
<i>Déroulement de l'assemblée générale:
i>L'assemblée générale extraordinaire débutera à 11.30 heures, y seront débattus les points à l'ordre du jour.
<i>Représentation à l'assemblée générale:
i>Pour le cas où un actionnaire ne serait pas à même d'assister personnellement à cette assemblée générale extraordi-
naire, il pourra voter par procuration. Des modèles de procuration sont disponibles sur simple demande effectuée par
courrier à RASEC INTERNATIONAL HOLDING, à l'attention de M. Patrick GENTIL, 4, rue de la Grève, L-1643 Lu-
xembourg, Luxembourg. Les procurations sont ensuite à retourner à l'adresse susmentionnée dans les meilleurs délais
et dans tous les cas avant le 4 août 2014 à 18.00 heure locale.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2014101776/30.
Dexia Luxpart, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 52.211.
Les actionnaires de Dexia Luxpart (la «Société») sont invités à assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
de la Société qui se tiendra le <i>7 août 2014i> à 11 heures dans les locaux de Candriam Luxembourg SA, 136, route d'Arlon
à L-1150 Luxembourg, pour délibérer sur la résolution unique suivante:
Après avoir entendu:
* le rapport du Conseil d'Administration de la Société expliquant et justifiant le projet de fusion (le «Projet de Fusion»)
publié au Mémorial et déposé au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, et
* le rapport de vérification prescrit par l'article 266 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales préparé
par KPMG Audit ayant son siège social à Luxembourg agissant en tant qu'expert indépendant concernant la fusion.
I. Approbation de la fusion de la Société avec le compartiment Europe Conviction (le «Compartiment absorbant») de
Candriam Equities L, une société d'investissement à capital variable organisée sous la loi luxembourgeoise et ayant son
siège social, 14, Porte de France à Esch-sur-Alzette (la «SICAV»).
II. Approbation de l'attribution aux actionnaires de la Société d'actions du Compartiment absorbant en échange de la
contribution par la Société de tous ses actifs et passifs avec effet à la date où la fusion deviendra effective (la «Date
Effective»), les nouvelles actions en question étant émises sur base de la parité déterminée par rapport aux valeurs nettes
d'inventaire de la Société à absorber et du Compartiment absorbant établies à une date proche des Assemblées appelées
à se prononcer sur la fusion.
Si, suite à l'échange, l'actionnaire se voit attribuer une fraction d'action, il pourra soit se faire racheter par le Com-
partiment absorbant cette fraction d'action sans frais, sauf taxes éventuelles, soit compléter sa fraction d'action moyennant
paiement, pour obtenir un nombre entier d'actions.
89666
L
U X E M B O U R G
III. Fixation de la Date Effective de la fusion au 20 août 2014 sur base des valeurs nettes d'inventaire de la Société et
du Compartiment absorbant du 19 août 2014 (dans le cas où la première assemblée ne pourrait délibérer pour faute de
quorum, fixation de la Date Effective de la fusion au 26 septembre 2014 sur base des valeurs nettes d'inventaire de la
Société et du Compartiment absorbant du 25 septembre 2014).
IV. Dissolution de la Société sans liquidation par apport de ses actifs au Compartiment absorbant.
V. Ratification du dividende payé depuis la clôture de septembre 2013.
VI. Décharge aux Administrateurs pour l'exécution de leur mandat jusqu'à la date de la présente Assemblée et dé-
termination du lieu où les documents sociaux seront conservés après la fusion pendant cinq années.
Les documents suivants peuvent être consultés par les actionnaires au siège de la Société pendant les heures d'ou-
verture normales des bureaux, et une copie peut en être obtenue sans frais:
* le Projet de Fusion;
* les rapports des Conseils d'Administration de la Société et de la SICAV;
* les rapports de KPMG Audit ayant son siège social à Luxembourg agissant en qualité d'expert indépendant de la
fusion;
* les prospectus actuels et les rapports annuels et semi-annuels des trois derniers exercices de la Société et de la
SICAV ainsi que les documents d'informations clés pour l'investisseur du Compartiment absorbant.
Les actionnaires sont informés que la résolution unique de l'Assemblée requière qu'au moins la moitié des actions en
circulation soit représentée et les résolutions, pour être valables, devront réunir les deux tiers au moins des voix expri-
mées.
Si ce quorum n'est pas atteint, une seconde assemblée sera convoquée avec la même résolution unique, mais pour
laquelle aucun quorum ne sera requis.
Le quorum et la majorité seront déterminés en fonction des actions émises et en circulation le cinquième jour qui
précède l'Assemblée, soit le 2 août 2014, à minuit (heure de Luxembourg). Les droits d'un actionnaire de participer à
l'Assemblée et d'exercer le droit de vote attaché à ses actions sont déterminés en fonction des actions détenues par cet
actionnaire à cette même date.
Les actionnaires qui désirent assister personnellement à l'Assemblée sont priés, pour des raisons d'organisation, de
s'inscrire avant le 4 août 2014 auprès de Candriam Luxembourg SA, 136, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, à l'attention
de Legal Fund Management (Fax N° +352 27 97 49 40).
Pour être admis à l'Assemblée, les propriétaires d'actions au porteur sont priés de déposer leurs actions cinq jours
calendaires avant l'Assemblée aux guichets de la Banque Internationale à Luxembourg, 69, route d'Esch, L-1470 Luxem-
bourg.
<i>Le Conseil d'Administrationi>
.
Référence de publication: 2014103682/755/58.
Neunheuser S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4384 Ehlerange, Z.A.R.E. Ouest.
R.C.S. Luxembourg B 161.952.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014067693/9.
(140078572) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2014.
DWS FlexPension, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 94.805.
Der Teilfonds DWS FlexPension 2013 wurde am 31. Dezember 2013 liquidiert.
Der Liquidationsprozess ist abgeschlossen. Die State Street Bank Luxembourg S.A., in ihrer Funktion als Depotbank,
hat das Teilfondsvermögen an die Anteilinhaber ausgezahlt. Es wurden keine Beträge an die Caisse de Consignation
überwiesen.
Luxemburg, im Juli 2014.
DWS FlexPension, SICAV.
Référence de publication: 2014103686/755/11.
89667
L
U X E M B O U R G
Trilantic Events Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 12.642,80.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 138.170.
Il résulte des actes de la Société que son associé Trïlantic Capital Partners VI (Europe) LP. a changé son adresse pour
le 35, Portman Square, W1H 6LR Londres (Royaume-Uni).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Trilantic Events Management S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Signatures
Référence de publication: 2014068500/14.
(140079885) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2014.
ADEPA Asset Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6A, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 114.721.
<i>Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale des Actionnaires de la société ADEPA Asset Management, S.A. du 22 mai 2013i>
(...)
(4) Approbation de la démission d'un administrateur:
a. Mr. José Pedro Caldeira, né à Lapa/Lisboa (Portugal), le 22 février 1959, demeurant à CH-1009 Pully (Suisse), 70A,
avenue Général Guisan, a démissionné le 13 mars 2013.
(...)
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2014069364/14.
(140081627) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2014.
Allianz Infrastructure Luxembourg Holdco I S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 14, boulevard F.D. Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 164.966.
In the year two thousand and fourteen, on the fourth day of July.
Before Us, Maître Marc Loesch, notary, residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,
is held
an extraordinary general meeting of the shareholders of Allianz Infrastructure Luxembourg Holdco I S.A., a Luxem-
bourg société anonyme, incorporated by a notarial deed drawn up on 24 November 2011, having its registered office at
14, boulevard Franklin D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Register of Commerce
and Companies ("RCS") under number B 164.966 and whose articles of association (the "Articles") have been published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") under number 2979, page 142.948 dated 6
December 2011 (the “Company”). The Articles have been amended for the last time on 31 January 2014 pursuant to a
deed of the undersigned notary published in the Mémorial under number 848, page 40671 on 2 April 2014.
The extraordinary general meeting of the Company (the "Meeting") is opened at 9.30 a.m. and elected as chairman Mr
Lars Junkermann, residing professionally in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Mrs Leysan Schoemann, residing professionally in Luxembourg.
The Meeting elected as scrutineer Mr Marc Schons, residing professionally in Luxembourg.
The office of the Meeting having thus been constituted, the chairman requested the notary to act that:
I. The names of the shareholders represented at the Meeting by proxies (together the "Appearing Shareholders") and
the number of shares held by them are shown on an attendance list at the end of these minutes. This attendance list has
been signed ne varietur with the proxy forms by the shareholders represented at the Meeting by proxies, the notary, the
chairman, the scrutineer and the secretary.
II. The attendance list shows that the whole share capital of the Company is represented. The Appearing Shareholders
have declared that they have been sufficiently informed of the agenda of the Meeting beforehand and have waived all
convening requirements and formalities. The Meeting can validly decide on all the items of the below agenda.
III. The agenda of the Meeting was the following:
89668
L
U X E M B O U R G
<i>Agendai>
1. To resolve to reduce the Company's share capital by an amount of thirty-seven million Euros (EUR 37,000,000)
from its current amount of seventy-eight million sixteen thousand seven hundred twenty Euros and sixty-four Cents (EUR
78,016,720.64) to forty-one million sixteen thousand seven hundred twenty Euros and sixty-four Cents (EUR
41,016,720.64) by the cancellation of three billion seven hundred million (3,700,000,000) Shares (the "Share Capital
Decrease").
2. To amend the first sentence of article 5 of the Articles (Share Capital) to reflect the Share Capital Decrease which
shall now read as follows:
" Art. 5. Share Capital. The subscribed share capital is set at forty-one million sixteen thousand seven hundred twenty
Euros and sixty-four Cents (EUR 41,016,720.64), fully paid up and represented by four billion one hundred one million
six hundred seventy-two thousand sixty-four (4,101,672,064) shares (the "Shares") with a par value one Euro cent (EUR
0.01) per share."
3. Miscellaneous.
The Meeting, declares and requests the undersigned notary to act that:
<i>First resolutioni>
The Meeting resolves to reduce the Company's share capital by an amount of thirty-seven million Euros (EUR
37,000,000) from its current amount of seventy-eight million sixteen thousand seven hundred twenty Euros and sixty-
four Cents (EUR 78,016,720.64) to forty-one million sixteen thousand seven hundred twenty Euros and sixty-four Cents
(EUR 41,016,720.64) by the cancellation of three billion seven hundred million (3,700,000,000) Shares (the "Share Capital
Decrease").
<i>Reimbursementi>
According to article 69 (2) of the Luxembourg law on commercial companies dated 10 August 1915 and as amended
from time to time, which establishes a legal protection in favor of creditors of the Company, in case the share capital
reduction is to be carried out by means of a repayment to shareholders or a waiver of their obligation to pay up their
shares, creditors whose claims predate the publication of the minutes of the meeting in the Mémorial may, within 30 days
from such publication, apply for the constitution of security to the judge presiding the chamber of the Tribunal d'Arron-
dissement dealing with commercial matters and sitting as in urgency matters. The president may only reject such an
application if the creditor already has adequate safeguards or if such security is unnecessary, having regard to the assets
of the Company. Additionally, the Company will not carry out the Share Capital Decrease before getting the authorization
according to article 7 of the Articles.
<i>Second resolutioni>
Further to the previous resolution, the Meeting resolves to amend the 1
st
sentence of article 5 of the Articles (Share
Capital) to reflect the Share Capital Decrease, which shall read as follows:
" Art. 5. Share Capital. The subscribed share capital is set at forty-one million sixteen thousand seven hundred twenty
Euros and sixty-four Cents (EUR 41,016,720.64), fully paid up and represented by four billion one hundred one million
six hundred seventy-two thousand sixty-four (4,101,672,064) shares (the "Shares") with a par value one Euro cent (EUR
0.01) per share."
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection this deed, have been estimated at about two thousand five hundred Euro (EUR 2,500).
There being no further business, the meeting is closed at 9.45 a.m..
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a German version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the German texts, the English version will be prevailing.
WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholders of the appearing parties, they signed together with the notary
the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des voranstehenden Textes
Im Jahre zweitausendundvierzehn, am vierten Juli,
wurde vor dem unterzeichnenden Notar Marc Loesch, mit Amtssitz in Bad-Mondorf, Großherzogtum Luxemburg,
eine Hauptversammlung der Aktiengesellschaft Allianz Infrastructure Luxembourg Holdco I S.A. (die "Aktiengesell-
schaft"), eine nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründete Aktiengesellschaft (société anonyme) mit
89669
L
U X E M B O U R G
Gesellschaftssitz in 14, boulevard F. D. Roosevelt, L-2450 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Han-
dels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés) unter der Nummer B 164.966,
gegründet durch notarielle Urkunde aufgenommen am 24. November 2011, die Satzung wurde am 6. Dezember 2011 im
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations ("Mémorial") unter der Nummer 2979, Seite 142948 veröffentlicht. Die
Satzung der Aktiengesellschaft wurde zuletzt abgeändert durch von dem unterzeichnenden Notar am 31. Januar 2014
aufgenommene Urkunde, im Mémorial veröffentlicht unter der Nummer 848, Seite 40671.
Die außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft (die "Hauptversammlung") wird um 9.30 Uhr eröffnet und
wählt als Vorsitzenden Herr Lars Junkermann, mit Berufsanschrift in Luxemburg.
Der Vorsitzende ernennt zum Schriftführer Frau Leysan Schoemann, mit Berufsanschrift in Luxemburg.
Zum Stimmzähler wird ernannt Herr Marc Schons, mit Berufsanschrift in Luxemburg.
Sodann stellt der Vorsitzende fest und bittet den Notar zu beurkunden:
I. Dass aus einer dieser Urkunde beigefügten Anwesenheitsliste, die Namen der Aktionäre, die auf dieser Hauptver-
sammlung durch Vollmachten vertreten sind (die "Erschienenen Aktionäre") und die von ihnen gehaltenen Aktien
hervorgehen. Diese Liste, von den Mitgliedern des Büros und dem unterzeichnenden Notar ne varietur unterzeichnet,
bleibt zusammen mit den Vollmachten dieser Urkunde, mit welcher sie einregistriert wird, als Anlage beigefügt.
II. Die Anwesenheitsliste belegt, dass das gesamte Gesellschaftskapital vertreten ist. Dass die Erschienenen Aktionäre
bestätigen, von der Tagesordnung Kenntnis zu haben, demgemäß ausdrücklich auf eine förmliche Einberufung verzichten
und sich zu dieser Versammlung ordnungsgemäß einberufen erklären. Die Hauptversammlung kann daher über alle Punkte
der Tagesordnung wirksam entscheiden.
III. Dass die Tagesordnung dieser Versammlung folgende Punkte umfasst:
<i>Tagesordnungi>
1. Beschlussfassung über die Herabsetzung des Gesellschaftskapitals um siebenunddreißig Millionen Euro (EUR
37.000.000) von derzeit achtundsiebzig Millionen sechszehntausendsiebenhundertzwanzig Euro und vierundsechzig Cents
(EUR 78.016.720,64) auf einundvierzig Millionen sechzehntausendsiebenhundertzwanzig Euro und vierundsechzig Cents
(EUR 41.016.720,64) durch die Vernichtung von drei Milliarden siebenhundert Millionen (3.700.000.000) Aktien (die
"Kapitalherabsetzung").
2. Den Artikel 5 der Satzung (Gesellschaftskapital) der Kapitalherabsetzung entsprechend abzuändern, der von nun an
wie folgt lauten soll:
" Art. 5. Gesellschaftskapital. Das gezeichnete und voll eingezahlte Gesellschaftskapital beträgt einundvierzig Millionen
sechzehntausendsiebenhundertzwanzig Euro und vierundsechzig Cents (EUR 41.016.720,64) und ist in vier Milliarden
einhundertein Millionen sechshundertzweiundsiebzigtausendvierundsechzig (4.101.672.064) Aktien (die "Aktien") mit ei-
nem Nennwert von einem Euro Cent (EUR 0,01) pro Aktie eingeteilt."
3. Sonstiges.
Die Versammlung erklärt und ersucht den unterzeichnenden Notar wie folgt zu beurkunden:
<i>Erster Beschlussi>
Die Versammlung beschließt das Gesellschaftskapital um einen Betrag von siebenunddreißig Millionen Euro (EUR
37.000.000) von derzeit achtundsiebzig Millionen sechszehntausendsiebenhundertzwanzig Euro und vierundsechzig Cents
(EUR 78.016.720,64) auf einundvierzig Millionen sechzehntausendsiebenhundertzwanzig Euro und vierundsechzig Cents
(EUR 41.016.720,64) durch die Vernichtung von drei Milliarden siebenhundert Millionen (3.700.000.000) Aktien herab-
zusetzen (die "Kapitalherabsetzung").
<i>Rückzahlungi>
Gemäß Artikel 69 (2) des Luxemburger Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, in geänderter
Fassung, welche einen Gläubigerschutz im Falle von Kapitalherabsetzungen für den Fall vorsieht, dass die Kapitalherab-
setzung durch Rückzahlung an die Aktionäre erfolgt oder eine Entbindung der Aktionäre von ihrer Verpflichtung ihre
Aktien einzuzahlen, so können Gläubiger, deren Forderungen vor der Veröffentlichung des Protokolls der Hauptver-
sammlung im Amtsblatt (Mémorial) entstanden ist, innerhalb von dreißig Tagen ab der Veröffentlichung beim Vorsitzenden
Richter des in Handelssachen tagenden tribunal d'arondissement im Eilverfahren die Stellung von Sicherheiten beantragen.
Der Vorsitzende kann diesen Antrag nur abweisen, wenn der Gläubiger bereits über ausreichende Sicherheiten verfügt
oder wenn solche in Anbetracht des Vermögens der Gesellschaft nicht notwendig sind. Zusätzlich kann die Gesellschaft
die Kapitalherabsetzung nicht durchführen, bevor sie die Zustimmung gemäß Artikel 7 der Satzung eingeholt hat.
<i>Zweiter Beschlussi>
Ferner zu dem oben genannten Beschluss, beschließt die Versammlung den 1. Satz des Artikels 5 der Satzung der
Gesellschaft (Gesellschaftskapital) zu ändern, um ihm fortan folgenden Wortlaut zu geben:
" Art. 5. Gesellschaftskapital. Das gezeichnete und voll eingezahlte Gesellschaftskapital beträgt einundvierzig Millionen
sechzehntausendsiebenhundertzwanzig Euro und vierundsechzig Cents (EUR 41.016.720,64) und ist in vier Milliarden
89670
L
U X E M B O U R G
einhundertein Millionen sechshundertzweiundsiebzigtausendvierundsechzig (4.101.672.064) Aktien (die "Aktien") mit ei-
nem Nennwert von einem Euro Cent (EUR 0,01) pro Aktie eingeteilt."
<i>Kosteni>
Jegliche Ausgaben, Kosten, Vergütungen oder sonstigen Ausgaben gleich welcher Art, die die Gesellschaft aufgrund
dieser notariellen Urkunde zu tragen hat, werden auf ungefähr zweitausendfünfhundert Euro (EUR 2.500) geschätzt.
Die Versammlung wird um 9.45 Uhr geschlossen.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache versteht und spricht, stellt hiermit fest, dass die vorliegende
Urkunde auf Verlangen der Erschienenen in englischer Sprache samt deutscher Übersetzung abgefasst wurde. Auf Ersu-
chen der gleichen Erschienenen soll im Falle von Divergenzen zwischen der englischen und der deutschen Fassung, die
englische Fassung Vorrang haben.
Worüber Urkunde, Aufgenommen in Luxemburg, am zum Beginn dieses Dokuments genannten Datum.
Nachdem das Dokument den Erschienenen vorgelesen worden war, unterzeichneten diese gemeinsam mit dem Notar
die vorliegende Urkunde.
Signé: L. Junkermann, L.Schoemann, M. Schons, M. Loesch.
Enregistré à Remich, le 8 juillet 2014. REM/2014/1474. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): P. MOLLING.
Pour expédition conforme,
Mondorf-les-Bains, le 11 juillet 2014.
Référence de publication: 2014100690/157.
(140120405) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.
Allianz Infrastructure Luxembourg Holdco II S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 14, boulevard F.D. Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 165.370.
In the year two thousand and fourteen, on the fourth day of July.
Before Us, Maître Marc Loesch, notary, residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,
is held
an extraordinary general meeting of the shareholders of Allianz Infrastructure Luxembourg Holdco II S.A., a Luxem-
bourg société anonyme, incorporated by a notarial deed drawn up on 24 November 2011, having its registered office at
14, Boulevard Franklin D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Register of Commerce
and Companies ("RCS") under number B 165.370 and whose articles of association (the "Articles") have been published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") under number 127, page 6056 dated 17 January
2012 (the “Company”). The Articles have been amended for the last time on 31 January 2014 pursuant to a deed of the
undersigned notary published in the Mémorial under number 864, page 41437 on 8 April 2014.
The extraordinary general meeting of the Company (the "Meeting") is opened at 9.46 a.m. and elected as chairman Mr
Lars Junkermann, residing professionally in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Mrs Leysan Schoemann, residing professionally in Luxembourg.
The Meeting elected as scrutineer Mr Marc Schons, residing professionally in Luxembourg.
The office of the Meeting having thus been constituted, the chairman requested the notary to act that:
I. The names of the shareholders represented at the Meeting by proxies (together the "Appearing Shareholders") and
the number of shares held by them are shown on an attendance list at the end of these minutes. This attendance list has
been signed ne varietur with the proxy forms by the shareholders represented at the Meeting by proxies, the notary, the
chairman, the scrutineer and the secretary.
II. The attendance list shows that the whole share capital of the Company is represented. The Appearing Shareholders
have declared that they have been sufficiently informed of the agenda of the Meeting beforehand and have waived all
convening requirements and formalities. The Meeting can validly decide on all the items of the below agenda.
III. The agenda of the Meeting was the following:
<i>Agendai>
1. Resolution to reduce the share capital by an amount of EUR 263,758.48 to bring the share capital from its current
amount of EUR 633,082.42 to EUR 369,323.94 by the cancellation of 26,375,848 shares with a nominal value of EUR 0.01
each repurchased by the Company pursuant to a resolution of the Company's Board of Directors dated 4 July 2014 at a
price of approximately EUR 3.87 per share (the "Repurchase Shares") for a total repurchase price of EUR 102,000,002
89671
L
U X E M B O U R G
(the "Total Repurchase Price"). Out of the Total Repurchase Price, EUR 263,758.48 represent the total nominal value of
the Repurchase Shares.
2. To amend the first sentence of article 5 of the Articles (Share Capital) to reflect the above mentioned share capital
decrease, which shall now read as follows:
" Art. 5. Share Capital. The subscribed share capital is set at three hundred sixty-nine thousand three hundred twenty-
three Euros and ninety-four Eurocents (EUR 369,323.94), fully paid up and represented by thirty-six million nine hundred
thirty-two thousand three hundred ninety-four (36,932,394) shares (the "Shares") with a par value one Euro cent (EUR
0.01) per share."
3. Miscellaneous.
The Meeting declares and requests the undersigned notary to act that:
<i>First resolutioni>
The Meeting resolves to reduce the share capital by an amount of EUR 263,758.48 to bring the share capital from its
current amount of EUR 633,082.42 to EUR 369,323.94 by the cancellation of 26,375,848 shares with a nominal value of
EUR 0.01 each repurchased by the Company pursuant to a resolution of the Company's Board of Directors dated 4 July
2014 at a price of approximately EUR 3.87 per share (the "Repurchase Shares") for a total repurchase price of EUR
102,000,002 (the "Total Repurchase Price"). Out of the Total Repurchase Price, EUR 263,758.48 represent the total
nominal value of the Repurchase Shares.
<i>Reimbursementi>
According to article 69 (2) of the Luxembourg law on commercial companies dated 10 August 1915 and as amended
from time to time, which establishes a legal protection in favor of creditors of the Company, in case the share capital
reduction is to be carried out by means of a repayment to shareholders or a waiver of their obligation to pay up their
shares, creditors whose claims predate the publication of the minutes of the meeting in the Mémorial may, within 30 days
from such publication, apply for the constitution of security to the judge presiding the chamber of the Tribunal d'Arron-
dissement dealing with commercial matters and sitting as in urgency matters. The president may only reject such an
application if the creditor already has adequate safeguards or if such security is unnecessary, having regard to the assets
of the Company. Additionally, the Company will not carry out the share capital decrease before getting the authorization
according to article 7 of the Articles.
<i>Second resolutioni>
Further to the previous resolution, the Meeting resolves to amend the first sentence of article 5 of the Articles (Share
Capital) to reflect the share capital decrease, which shall read as follows:
" Art. 5. Share Capital. The subscribed share capital is set at three hundred sixty-nine thousand three hundred twenty-
three Euros and ninety-four Eurocents (EUR 369,323.94), fully paid up and represented by thirty-six million nine hundred
thirty-two thousand three hundred ninety-four (36,932,394) shares (the "Shares") with a par value one Euro cent (EUR
0.01) per share."
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection this deed, have been estimated at about two thousand five hundred Euro (EUR 2,500).
There being no further business, the meeting is closed at 10.00 a.m..
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a German version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the German texts, the English version will be prevailing.
WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholders of the appearing parties, they signed together with the notary
the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des voranstehenden Textes:
Im Jahre zweitausendundvierzehn, am vierten Juli,
wurde vor dem unterzeichnenden Notar Marc Loesch, mit Amtssitz in Bad-Mondorf, Großherzogtum Luxemburg,
eine Hauptversammlung der Aktiengesellschaft Allianz Infrastructure Luxembourg Holdco II S.A. (die "Aktiengesell-
schaft"), eine nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründete Aktiengesellschaft (société anonyme) mit
Gesellschaftssitz in 14, boulevard F. D. Roosevelt, L-2450 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Han-
dels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés) unter der Nummer B 165.370,
gegründet durch notarielle Urkunde aufgenommen am 24. November 2011, die Satzung wurde am 17. Januar 2012 im
89672
L
U X E M B O U R G
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations ("Mémorial") unter der Nummer 127, Seite 6056 veröffentlicht. Die
Satzung der Aktiengesellschaft wurde zuletzt abgeändert durch eine von dem unterzeichnenden Notar am 31. Januar 2014
aufgenommene Urkunde, im Mémorial veröffentlicht unter der Nummer 848, Seite 40671.
Die außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft (die "Hauptversammlung") wird um 9.46 Uhr eröffnet und
wählt als Vorsitzenden Herrn Lars Junkermann, mit Berufsanschrift in Luxemburg.
Der Vorsitzende ernennt zum Schriftführer Frau Leysan Schoemann, mit Berufsanschrift in Luxemburg.
Zum Stimmzähler wird ernannt Herr Marc Schons, mit Berufsanschrift in Luxemburg.
Sodann stellt der Vorsitzende fest und bittet den Notar zu beurkunden:
I. Dass aus einer dieser Urkunde beigefügten Anwesenheitsliste, die Namen der Aktionäre, die auf dieser Hauptver-
sammlung durch Vollmachten vertreten sind (die "Erschienenen Aktionäre") und die von ihnen gehaltenen Aktien
hervorgehen. Diese Liste, von den Mitgliedern des Büros und dem unterzeichnenden Notar ne varietur unterzeichnet,
bleibt zusammen mit den Vollmachten dieser Urkunde, mit welcher sie einregistriert wird, als Anlage beigefügt.
II. Die Anwesenheitsliste belegt, dass das gesamte Gesellschaftskapital vertreten ist. Dass die Erschienenen Aktionäre
bestätigen, von der Tagesordnung Kenntnis zu haben, demgemäß ausdrücklich auf eine förmliche Einberufung verzichten
und sich zu dieser Versammlung ordnungsgemäß einberufen erklären. Die Hauptversammlung kann daher über alle Punkte
der Tagesordnung wirksam entscheiden.
III. Dass die Tagesordnung dieser Versammlung folgende Punkte umfasst:
<i>Tagesordnungi>
1. Beschlussfassung über die Herabsetzung des Gesellschaftskapitals um EUR 263.758,48 von derzeit EUR 633.082,42
auf EUR 369.323,94 herabzusetzen, durch die Vernichtung von 26.375.848 Aktien mit einem Nennwert von je EUR 0,01,
welche von der Gesellschaft gemäß Beschluss des Verwaltungsrats der Gesellschaft mit Datum vom 4. Juli 2014 zu einem
Preis von etwa EUR 3,87 pro Aktie (die "Rückkauf-Aktien") zu einem Gesamtrückkaufspreis von EUR 102.000.002 (der
"Gesamtrückkaufspreis") zurückgekauft werden. Von dem Gesamtrückkaufspreis stellen EUR 263.758,48 den Gesamt-
nennwert der Rückkauf-Aktien dar.
2. Den Artikel 5 der Satzung (Gesellschaftskapital) der Kapitalherabsetzung entsprechend abzuändern, der von nun an
wie folgt lauten soll:
" Art. 5. Gesellschaftskapital. Das gezeichnete und voll eingezahlte Gesellschaftskapital beträgt dreihundertneunund-
sechzigtausenddreihundertdreiundzwanzig Euro und vierundneunzig Euro Cent (EUR 369.323,94) und ist in sechsund-
dreißig Millionen neunhundertzweiundreißigtausenddreihundertvierundneunzig (36.932.394) Aktien (die "Aktien") mit
einem Nennwert von einem Euro Cent (EUR 0,01) pro Aktie eingeteilt."
3. Sonstiges.
Die Versammlung erklärt und ersucht den unterzeichnenden Notar wie folgt zu beurkunden:
<i>Erster Beschlussi>
Die Versammlung beschließt das Gesellschaftskapital um EUR 263.758,48 von derzeit EUR 633.082,42 auf EUR
369.323,94 herabzusetzen, durch die Vernichtung von 26.375.848 Aktien mit einem Nennwert von je EUR 0,01, welche
von der Gesellschaft gemäß Beschluss des Verwaltungsrats der Gesellschaft mit Datum vom 4. Juli 2014 zu einem Preis
von etwa EUR 3,87 pro Aktie (die "Rückkauf-Aktien") zu einem Gesamtrückkaufspreis von EUR 102.000.002 (der "Ge-
samtrückkaufspreis") zurückgekauft werden. Von dem Gesamtrückkaufspreis stellen EUR 263.758,48 den Gesamtnenn-
wert der Rückkauf-Aktien dar.
<i>Rückzahlungi>
Gemäß Artikel 69 (2) des Luxemburger Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, in geänderter
Fassung, welche einen Gläubigerschutz im Falle von Kapitalherabsetzungen für den Fall vorsieht, dass die Kapitalherab-
setzung durch Rückzahlung an die Aktionäre erfolgt oder eine Entbindung der Aktionäre von ihrer Verpflichtung ihre
Aktien einzuzahlen, so können Gläubiger, deren Forderungen vor der Veröffentlichung des Protokolls der Hauptver-
sammlung im Amtsblatt (Mémorial) entstanden ist, innerhalb von dreißig Tagen ab der Veröffentlichung beim Vorsitzenden
Richter des in Handelssachen tagenden tribunal d'arondissement im Eilverfahren die Stellung von Sicherheiten beantragen.
Der Vorsitzende kann diesen Antrag nur abweisen, wenn der Gläubiger bereits über ausreichende Sicherheiten verfügt
oder wenn solche in Anbetracht des Vermögens der Gesellschaft nicht notwendig sind. Zusätzlich kann die Gesellschaft
die Kapitalherabsetzung nicht durchführen, bevor sie die Zustimmung gemäß Artikel 7 der Satzung eingeholt hat.
<i>Zweiter Beschlussi>
Ferner zu dem oben genannten Beschluss, beschließt die Versammlung den 1. Satz des Artikels 5 der Satzung der
Gesellschaft (Gesellschaftskapital) zu ändern, um ihm fortan folgenden Wortlaut zu geben:
" Art. 5. Gesellschaftskapital. Das gezeichnete und voll eingezahlte Gesellschaftskapital beträgt dreihundertneunund-
sechzigtausenddreihundertdreiundzwanzig Euro und vierundneunzig Euro Cent (EUR 369.323,94) und ist in sechsund-
89673
L
U X E M B O U R G
dreißig Millionen neunhundertzweiundreißigtausenddreihundertvierundneunzig (36.932.394) Aktien (die "Aktien") mit
einem Nennwert von einem Euro Cent (EUR 0,01) pro Aktie eingeteilt."
<i>Kosteni>
Jegliche Ausgaben, Kosten, Vergütungen oder sonstigen Ausgaben gleich welcher Art, die die Gesellschaft aufgrund
dieser notariellen Urkunde zu tragen hat, werden auf ungefähr zweitausendfünfhundert Euro (EUR 2.500) geschätzt.
Die Versammlung wird um 10.00 Uhr geschlossen.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache versteht und spricht, stellt hiermit fest, dass die vorliegende
Urkunde auf Verlangen der Erschienenen in englischer Sprache samt deutscher Übersetzung abgefasst wurde. Auf Ersu-
chen der gleichen Erschienenen soll im Falle von Divergenzen zwischen der englischen und der deutschen Fassung, die
englische Fassung Vorrang haben.
Worüber Urkunde, Aufgenommen in Luxemburg, am zum Beginn dieses Dokuments genannten Datum.
Nachdem das Dokument den Erschienenen vorgelesen worden war, unterzeichneten diese gemeinsam mit dem Notar
die vorliegende Urkunde.
Signé: L. Junkermann, L. Schoemann, M. Schons, M. Loesch.
Enregistré à Remich, le 8 juillet 2014. REM/2014/1475. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): P. MOLLING.
Pour expédition conforme,
Mondorf-les-Bains, le 11 juillet 2014.
Référence de publication: 2014100691/161.
(140120413) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2014.
Feri Trust (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 18, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 128.987.
Im Jahr zweitausendvierzehn, am siebenundzwanzigsten Juni.
vor dem unterzeichneten Notar Maître Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
IST ERSCHIENEN:
Feri AG einer Gesellschaft nach deutschem Recht, mit Sitz in D-61348 Bad Homburg, Haus am Park, Rathausplatz
8-10,
ier vertreten durch Corinna Schibgilla, Rechtsanwältin, beruflich ansässig in Luxemburg,
gemäß privatschriftlicher Vollmacht, ausgestellt am 25. Juni 2014, in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
welche nach Unterzeichnung ne varietur durch die Erschienene und den unterzeichneten Notar gegenwärtiger Ur-
kunde als Anlage beigefügt wird, um mit derselben registriert zu werden.
Die erschienene Partei ist alleinige Aktionärin (die „alleinige Aktionärin“) der Feri Trust (Luxembourg) S.A. einer
Société anonyme, (die „Gesellschaft“). Die Gesellschaft wurde am 23. Mai 2007 gemäß notarieller Urkunde durch den
Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg, unter der Firma „Institutional Trust Management Company S.à r.l.“
gegründet. Die Gründungsurkunde wurde im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1305 vom 29.
Juni 2007 veröffentlicht. Am 22. März 2012 wurde die Gesellschaft von einer S.à r.l. (Société à responsabilité limitée) in
eine S.A. (Société anonyme) umgewandelt und in „Feri Trust (Luxembourg) S.A.“ umbenannt. Die Satzung der Gesellschaft
wurde zum letzten Mal am 14. November 2012 gemäß notarieller Urkunde durch den Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitz
in Luxemburg, geändert und im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 182 vom 24. Januar 2013
veröffentlicht.
Hiernach fasst die das gesamte Gesellschaftskapital vertretende alleinige Aktionärin folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die alleinige Aktionärin beschließt, Artikel 4 der Satzung wie folgt zu ändern:
„Zweck der Gesellschaft ist die kollektive Portfolioverwaltung (inkl. sämtlicher in Anhang II des Gesetzes vom 17.
Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen, in seiner jeweils gültigen Fassung (das „Gesetz von 2010“)
genannten Aufgaben) eines oder mehrerer Luxemburger und/oder ausländischer Organismen für gemeinsame Anlagen
in Wertpapieren, welche der Richtlinie 2009/65/EG, in ihrer jeweils geltenden Fassung unterliegen (die „OGAWS“), dies
im Namen der Anteilsinhaber und im Einklang mit den Bestimmungen des Kapitel 15 des Gesetzes von 2010.
Zweck der Gesellschaft ist außerdem die kollektive Portfolioverwaltung anderer Luxemburger oder ausländischer
Organismen für gemeinsame Anlagen, die nicht unter vorbenannte Richtlinie fallen (die „OGAs“) und nicht als alternative
89674
L
U X E M B O U R G
Investmentfonds (die „AIFs“) im Sinne der Richtlinie 2011/61/EU in ihrer jeweils geltenden Fassung gelten, einschließlich
spezialisierter Investmentfonds gemäß dem Gesetz vom 13. Februar 2007 sowie die Verwaltung, die Administration und
der Vertrieb von Luxemburger Investmentgesellschaften zur Anlage in Risikokapital im Sinne des Gesetzes vom 15. Juni
2004 über Investmentgesellschaften zur Anlage in Risikokapital.
Zweck der Gesellschaft ist außerdem die Verwaltung Luxemburger oder ausländischer AIFs (inkl. sämtlicher in Anhang
I des Gesetzes vom 12. Juli 2013 über Verwalter alternativer Investmentfonds genannten Aufgaben).
Die Gesellschaft kann eine oder mehrere vorbenannter Aufgaben zum Zwecke einer effizienteren Geschäftsführung
an Dritte übertragen, die diese Aufgaben für sie wahrnehmen.
Die Gesellschaft kann ergänzend auch ihr eigenes Vermögen verwalten, sie kann ihre Tätigkeiten im In- und Ausland
ausüben, Zweigniederlassungen errichten, strukturell erforderliche Mehrheits- oder Minderheitsbeteiligungen an Invest-
mentgesellschaften oder SPVs halten, als Komplementär von solchen Investmentgesellschaften oder SPVs agieren und alle
sonstigen Geschäfte betreiben, die für die Erreichung ihres Zweckes förderlich sind und im Rahmen der gesetzlichen
Bestimmungen, insbesondere derjenigen des Gesellschaftsgesetzes, von Kapitel 15 des Gesetzes von 2010 und des Ge-
setzes vom 12. Juli 2013, bleiben.“
<i>Zweiter Beschlussi>
Die alleinige Aktionärin beschließt, Artikel 14, erster Satz der Satzung wie folgt zu ändern:
„Neben dem Aufsichtsrat wird die Gesellschaft nach Maßgabe des Gesetzes von 2010 einem oder mehreren unab-
hängigen Wirtschaftsprüfern (réviseur d’entreprises agréé) überwacht.“
<i>Dritter Beschlussi>
Die alleinige Aktionärin beschließt, einen Verweis auf das Gesetz von 2010 und das Gesetz vom 12. Juli 2013 in Artikel
25 der Satzung einzufügen. Artikel 25 wird demnach wie folgt geändert:
„Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, gilt das Gesellschaftsgesetz, das Gesetz von 2010 und das
Gesetz vom 12. Juli 2013.“
Worüber diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen wurde.
Und nach Vorlesung an die Bevollmächtigte der erschienenen Partei hat die Bevollmächtigte gegenwärtige Urkunde
mit dem Notar unterzeichnet.
Gezeichnet: C. SCHIBGILLA und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 juillet 2014. Relation: LAC/2014/30627. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - der Gesellschaft auf Begehr erteilt.
Luxemburg, den 9. Juli 2014.
Référence de publication: 2014099113/66.
(140118318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2014.
Octave Investissement S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.
R.C.S. Luxembourg B 116.673.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014067704/9.
(140079110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2014.
DWS Institutional, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 38.660.
Der Teilfonds DWS Institutional Fixed Maturity I wurde am 19. April 2013 liquidiert.
Der Liquidationsprozess ist abgeschlossen. Die State Street Bank Luxembourg S.A., in ihrer Funktion als Depotbank,
hat das Teilfondsvermögen an die Anteilinhaber ausgezahlt. Es wurden keine Beträge an die Caisse de Consignation
überwiesen.
Luxemburg, im Juli 2014.
DWS Institutional, SICAV.
Référence de publication: 2014103685/755/11.
89675
L
U X E M B O U R G
DWS Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 74.377.
Der Teilfonds DWS Funds Top DivideX Garant 2013 wurde am 28. Mai 2013 liquidiert.
Der Liquidationsprozess ist abgeschlossen. Die State Street Bank Luxembourg S.A., in ihrer Funktion als Depotbank,
hat das Teilfondsvermögen an die Anteilinhaber ausgezahlt. Es wurden keine Beträge an die Caisse de Consignation
überwiesen.
Luxemburg, im Juli 2014.
DWS Funds, SICAV.
Référence de publication: 2014103683/755/11.
FPM Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 80.070.
Der Teilfonds FPM Funds Stockpicker Germany All Cap wurde am 26. August 2013 liquidiert.
Der Liquidationsprozess ist abgeschlossen. Die State Street Bank Luxembourg S.A., in ihrer Funktion als Depotbank,
hat das Teilfondsvermögen an die Anteilinhaber ausgezahlt. Es wurden keine Beträge an die Caisse de Consignation
überwiesen.
Luxemburg, im Juli 2014.
FPM Funds, SICAV.
Référence de publication: 2014103684/755/11.
D3fine S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Aberro S.A.).
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.
R.C.S. Luxembourg B 123.030.
Im Jahre zweitausendvierzehn, den zwanzigsten Juni.
Vor dem unterzeichneten Notar Martine SCHAEFFER, mit Amtssitz in Luxemburg, (Großherzogtum Luxemburg).
IST ERSCHIENEN:
Herr Dag RINGDAL, Geschäftsmann, geboren in Baerum (Norwegen) am 9. September 1967 und wohnhaft in 25,
Cité am Wenkel, L-8086 Bertrange.
Der alleinige Aktionär hat den unterzeichneten Notar ersucht, folgendes festzuhalten:
I. Er ist der alleinige Aktionär von "ABERRO S.A.", eine Aktiengesellschaft („société anonyme“), mit Sitz in 25C, Bou-
levard Royal, L-2449 Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg, Sektion B, unter der
Nummer 123.030, gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch Maître Jean-Joseph WAGNER, Notar mit Amtssitz in
Sanem (Großherzogtum Luxemburg), am 21. Dezember 2006, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, Nummer 255 vom 27. Februar 2007. Die Satzung der Gesellschaft wurde seither noch nicht abgeändert.
II. Die Tagesordnung der Versammlung ist wie folgt:
1. Abschaffung der englischen und französichen Fassung der Satzung der Gesellschaft und Einführung der deutschen
Sprache welche die Satzung der Gesellchaft von nun an auschließlich bestimmen wird;
2. Verlegung des Sitzes der Gesellschaft von 25C, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg nach 25, Cité am Wenkel,
L-8086 Bertrange;
3. Abänderung des Zweckes der Gesellschaft um ihm von nun an folgenden Wortlaut zu geben:
„Zweck der Gesellschaft sind die Dienstleistungen im Wirtschafts- und Informatiksektor.
Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten ausführen die sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder
denselben fördern.“;
4. In Hinsicht auf den Ausgleich eines Teils der in der Bilanz vom 31. Dezember 2013 verbuchten Verluste und bezu-
gnehmend auf das am 31. Dezember 2013 geschlossene Geschäftsjahr, Herabsetzung des Gesellschaftskapitals um einen
Betrag von achtzehntausend fünfhundert Euro (18.500.- EUR), um es von seinem aktuellen Betrag von einunddreißigtau-
send Euro (31.000.-EUR) auf zwölftausendfünfhundert Euro (12.500.- EUR) herabzusetzen, durch dementsprechende
Herabsetzung der dreitausendeinhundert (3.100) bestehenden Aktien auf eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Aktien
mit einem Nennwert von jeweils zehn Euro (10.- EUR), UND darauffolgende
Umwandlung der Form der Gesellschaft von einer Aktiengesellschaft („société anonyme“) in eine Gesellschaft mit
beschränkter Haftung („société à responsabilité limitée“) basierend auf einer Basis der Aktiva und Passiva Situation zum
89676
L
U X E M B O U R G
16. Juni 2014 und eines Bewertungszertifikates der Verwaltungsratsmitglieder vom 19. Juni 2014, hinsichtlich der Eigen-
mittel (Situation Aktiva und Passiva) der Gesellschaft;
5. Bezugnehemend auf die Umwandlung der Geselslchaft von einer Aktiengesellschaft („société anonyme“) in eine
Gesellschaft mit beschränkter Haftung („société à responsabilité limitée“), Abänderung des Namens der Gesellschaft in
„D3fine S.à r.l.“;
6. Anpassung der Satzung der Gesellschaft an die neue Form der Gesellschaft und gesamtheitliche Umgestaltung der
Satzung der Gesellschaft;
7. Bestimmung von zwei (2) Geschäftsführern an Stelle der abtretenden Verwaltungsratsmitglieder; Feststellung der
Abretung des Kommissars;
8. Abtretung von eintausend fünfhundertfünfzig (1.550) Geschäftsanteilen welche von Herrn Dag RINGDAL gehalten
werden an Frau Lene Ørum RINGDAL;
9. Verschiedenes.
Sodann hat die erschienene Partei den unterzeichneten Notar ersucht folgende Beschlüsse zu beurkunden:
<i>Erster Beschlussi>
Der alleinige Aktionär beschließt, die französische und englische Fassung der Satzung abzuschafften um die deutsche
Sprache einzuführen, welche die Satzung der Gesellschaft von nun an ausschließlich bestimmen wird.
<i>Zweiter Beschlussi>
Der alleinige Aktionär beschließt, den Sitz der Gessellschaft von 25C, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg nach 26,
rue Philippe II, L-2340 Luxemburg zu verlegen.
<i>Dritter Beschlussi>
Der alleinige Aktionär beschließt, den Zweck der Gesellschaft abzuändern um ihm von nun an folgenden Wortlaut zu
geben:
„Zweck der Gesellschaft sind die Dienstleistungen im Wirtschafts-und Informatiksektor.
Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten ausführen die sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder
denselben fördern.“
<i>Vierter Beschlussi>
Der alleinige Aktionär beschließt, in Hinsicht auf den Ausgleich eines Teils der in der Bilanz vom 31. Dezember 2013
verbuchten Verluste und in Bezug auf das am 31. Dezember 2013 geschlossene Geschäftsjahr,
die Herabsetzung des Gesellschaftskapitals um einen Betrag von achtzehntausend fünfhundert Euro (18.500.- EUR),
um es von seinem aktuellen Betrag von einunddreißigtausend Euro (31.000.- EUR) auf zwölftausendfünfhundert Euro
(12.500.- EUR) herabzusetzen, durch dementsprechende Herabsetzung der dreitausendeinhundert (3.100) bestehenden
Aktien auf eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Aktien mit einem Nennwert von jeweils zehn Euro (10.- EUR),
wobei die Herabsetzung des Gesellschaftskapitals in Höhe von achtzehntausend fünfhundert Euro (18.500.- EUR),
welche zwecks Ausgleichung eines Teils der verbuchten Verluste in selber Höhe, und welcher Betrag auf der Bilanz des
am 31. Dezember 2013 geschlossenen Geschäftsjahres aufgeführt ist, durchgeführt wird.
Der Beweis des Bestandes der zum 31. Dezember 2013 bestehenden Verluste, wird dem Notar durch Vorlage der
Bilanz zum 31. Dezember 2013 erbracht, welche ordnungsgemäß durch die Generalversammlung vom 18. Juni 2014
angenommen wurde. Eine Kopie dieser Bilanz bleibt gegenwärtiger Urkunde beigefügt.
Der alleinige Aktionär beschließt, weiterhin die Form der Gesellschaft ohne Abänderung der juristischen Person ab-
zuändern und die Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung anzunehmen.
Das gezeichnete Kapital sowie die Rücklagen bleiben unverändert bestehen, des Weiteren wie alle weiteren Aktiva
und Passiva, Abschreibungen, Minderungs- oder Mehrheitswerte und die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird die
Eintragungen sowie die Buchhaltung der Aktiengesellschaft fortführen. Die Umwandlung der Gesellschaft erfolgt auf Basis
der Aktiva und Passiva Situation der Gesellschaft zum 16. Juni 2014 sowie eines Bewertungszertifikates der Verwaltungs-
ratsmitglieder vom 19. Juni 2014,
wobei ein Exemplar dieser Aktiva und Passiva Situation sowie des Bewertungszertifikates, gegenwärtiger Urkunde
beigebogen werden, um mit ihr einregistriert zu werden.
Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft nach Umwandlung beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500.- EUR),
eingeteilt in eintausend zweihundertfünfzig (1.250) Anteile von je zehn Euro (10.- EUR).
Alle Geschäftsvorgänge der Aktiengesellschaft sind ab dem heutigen Datum als durch die Gesellschaft mit beschränkter
Haftung vorgenommen anzusehen, insbesondere hinsichtlich der Erstellung der Gesellschaftskonten.
89677
L
U X E M B O U R G
<i>Fünfter Beschlussi>
Bezugnehmend auf die Umwandlung der Gesellschaft von einer Aktiengesellschaft („société anonyme“) in eine Ge-
sellschaft mit beschränkter Haftung („société à responsabilité limitée“), beschließt der alleinige Gesellschafter den Namen
der Gesellschaft in „D3fine S.à r.l.“abzuändern.
<i>Sechster Beschlussi>
Der alleninge Gesellschafter beschließt, die Satzung der Gesellschaft an die neue Form der Gesellschaft anzupassen
und beschließt somit die gesamtheitliche Umgestaltung der Satzung wie folgt:
„I. Zweck, Dauer, Name, Sitz
Art. 1. Hiermit wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Luxemburger Recht (nachstehend die „Gesell-
schaft“) gegründet, die durch die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften,
neueste Fassung, sowie durch nachstehende Satzung geregelt wird.
Art. 2. Der Name der Gesellschaft lautet „D3fine S.à r.l.“.
Die Dauer der Gesellschaft ist unbefristet.
Art. 3. Zweck der Gesellschaft sind die Dienstleistungen im Wirtschafts- und Informatiksektor.
Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten ausführen die sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder
denselben fördern.
Art. 4. Der Gesellschaftssitz wird in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg festgelegt.
Der Sitz kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung an jeden anderen Ort in der Gemeinde Luxemburg
verlegt werden durch einfachen Beschluß der Verwalter.
II. Gesellschaftskapital, Anteile
Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500.- EUR), aufgeteilt in eintausend zwei-
hundertfünfzig (1.250) Anteile mit einem Nennwert von je zen Euro (10.- EUR) pro Anteil.
Jeder Anteil gewährt jeweils ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Gesellschafterversammlungen.
Art. 6. Die Änderung des Gesellschaftskapitals bedarf der Zustimmung der Mehrheit der Gesellschafter wobei diese
Mehrheit drei Viertel des Kapitals vertreten muss.
Art. 7. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil an. Miteigentümer eines einzelnen Anteils
müssen eine Person ernennen, die beide gegenüber der Gesellschaft vertritt.
Art. 8. Rechtsgeschäftliche Verfügungen eines Gesellschafters über seinen Gesellschaftsanteil oder Teilen hiervon be-
dürfen zu ihrer Wirksamkeit eines zustimmenden Beschlusses aller anderen Gesellschafter.
Art. 9. Gläubiger oder Rechtsnachfolger der Gesellschafter dürfen unter keinen Umständen Siegel an Vermögensge-
genständen oder Dokumenten der Gesellschaft anbringen.
Art. 10. Der Tod, die Insolvenz oder die Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters bewirkt nicht die Auflösung der
Gesellschaft.
III. Geschäftsführung
Art. 11. Die Gesellschaft wird geführt durch einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Geschäftsführer müssen nicht
Gesellschafter sein.
Die Geschäftsführer werden von der Gesellschafterversammlung ernannt. Die Gesellschafterversammlung bestimmt
auch die Dauer ihres Mandates. Die Geschäftsführer können jederzeit, ohne Angabe von Gründen aus ihren Funktionen
entlassen werden.
Dritten gegenüber wird die Gesellschaft rechtmäßig vertreten durch die alleinige Unterschrift des alleinigen Ge-
schäftsführers oder im Falle von mehreren Geschäftsführern durch die gemeinsame Unterschrift von zwei (2) Geschäfts-
führern.
Die Geschäftsführer sind von etwaigen Beschränkungen des Selbstkontrahierens befreit. Vollmachten werden durch
die Geschäftsführer privatschriftlich oder aufgrund notariell beglaubigter Urkunde erteilt.
Art. 12. Durch den Tod oder den Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchem Grund auch immer, wird die Ge-
sellschaft nicht aufgelöst.
Art. 13. Es besteht keine persönliche Haftung der Geschäftsführer für Verbindlichkeiten, die sie vorschriftsmäßig im
Namen der Gesellschaft eingehen. Als Bevollmächtigte sind sie lediglich für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich.
89678
L
U X E M B O U R G
IV. Entscheidungen der Gesellschafter, Gesellschafterversammlung
Art. 14. Jeder Gesellschafter kann an den Gesellschafterversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von
der Anzahl der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaft-
santeile besitzt oder vertritt.
Art. 15. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern angenommen werden,
die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten. Die Abänderung der Satzung benötigt die Zustimmung
(i) der einfachen Mehrheit der Gesellschafter,
(ii) die wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.
Art. 16. Sollte die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter haben, so übt dieser die Befugnisse aus, die der Gesell-
schafterversammlung gemäß Sektion XII des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neueste
Fassung, zustehen.
V. Geschäftsjahr, Konten, Gewinnausschüttungen
Art. 17. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember
desselben Jahres.
Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.
Art. 18. Fünf Prozent (5%) des Nettogewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent
(10%) des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.
Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva sowie den Gewinnen und Verlusten
der Gesellschaft.
VI. Gesellschaftsauflösung, Liquidation
Art. 19. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Gesellschaf-
terversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschafterver-
sammlung legt Befugnisse und Vergütungen der Liquidatoren fest. Die Liquidatoren haben alle Befugnisse zur Verwertung
der Vermögensguter und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft. Der nach Begleichung der Verbindlichkeiten
der Gesellschaft bestehende Überschuss wird unter den Gesellschaftern im Verhältnis zu dem ihnen zustehenden Kapi-
talanteil aufgeteilt.“
<i>Siebter Beschlussi>
Die folgenden Personen, treten mit Wirkung zum heutigen Tag von ihrem Amt als Verwaltungsratsmitglied der Ge-
sellschaft zurück:
- E&A Management S.A.;
- Herr Paulo Jorge DA COSTA MAGALHÃES; und
- Herr Gabriel EL RHILANI.
Des Weiteren stellt der allenige Gesellschafter fest, dass der Kommissar der Gesellschaft D.E. Révision, ebenfalls von
seinem Amt zurück tritt.
Der allenige Gesellschafter erteilt den Verwaltungsratsmitgliedern sowie dem Kommissar volle und einheitliche Ent-
lastung für die Ausführung ihrer Mandate als Verwaltungsratsmitglieder und Kommissar der Gesellschaft, bis zum heutigen
Tag.
<i>Achter Beschlussi>
Der allenige Gesellschafter beschließt, die Zahl der Geschäftsführer auf zwei (2) festzulegen.
Folgende Personen werden zu Geschäftsführern der Gesellschaft auf unbestimmte Zeit ernannt:
- Herr Dag RINGDAL, Geschäftsmann, geboren in Baerum (Norwegen) am 9. September 1967 und wohnhaft in 25,
Cité am Wenkel, L-8086 Bertrange; und
- Frau Lene Ørum RINGDAL, Geschäftsfrau, geboren in Kopenhagen (Dänemark) am 29. April 1965 und wohnhaft in
25, Cité am Wenkel, L-8086 Bertrange.
<i>Neunter Beschlussi>
Der vorbenannte alleinige Gesellschafter Herr Dag RINGDAL tritt eintausend sechshundertfünfundzwanzig (625) sei-
ner Anteile mit sofortiger Wirkung an
Frau Lene Ørum RINGDAL, Geschäftsfrau, geboren in Kopenhagen (Dänemark) am 29. April 1965 und und wohnhaft
in 25, Cité am Wenkel, L-8086 Bertrange, ab, welche hier anwesend ist und dies annimmt.
Somit werden die eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Anteile der Gesellschaft von nun an wie folgt gehalten:
89679
L
U X E M B O U R G
1) Herr Dag RINGDAL, vorbenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
625 Anteile
2) Frau Lene Ørum RINGDAL, vorbenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
625 Anteile
Gesamt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.250 Anteile
Diese Anteilsübertragung wurde getätigt mit dem Einverständnis aller Gesellschafter und soweit wie nötig durch die
beiden Geschäftsführer der Gesellschaft Herr Dag RINGDAL, vorbenannt und Frau Lene Ørum RINGDAL, vorbenannt,
angenommen.
Da die Tagesordnung erschöpft ist, erklären die Komparenten, handelnd wie eingangs erwähnt, die Gesellschafter-
versammlung für geschlossen.
<i>Kosteni>
Die Kosten, die der Gesellschaft aufgrund gegenwärtiger Urkunde erwachsen, werden auf den Betrag von dreitausend
Euro (3.000.- EUR) abgeschätzt.
WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorhergehenden an die Komparenten, haben dieselben mit Uns, Notar, ge-
genwärtige Urkunde unterschrieben.
Signé: D. Ringdal et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 24 juin 2014. Relation: LAC/2014/28933 Reçu soixante-quinze euros Eur 75.-
<i>Le Receveuri>
(signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de
Commerce.
Luxembourg, le 30 juin 2014.
Référence de publication: 2014091783/206.
(140108962) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juillet 2014.
Payment Consultants S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2728 Luxembourg, 12, rue Jules Wilhelm.
R.C.S. Luxembourg B 186.423.
AUSZUG
ÄNDERUNG DER ADRESSE DES GESCHÄFTSFÜHRERS
Die Adresse des Geschäftsführers von Herrn Ruben WEIGAND ist ab heutigem Datum folgende:
12, rue Jules Wilhelm
L-2728 Luxembourg
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 14. Mai 2014.
Référence de publication: 2014068380/14.
(140079555) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2014.
Gresham Borehamwood IP S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 914.980,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 104.780.
<i>Rectificatif du dépôt N°L060109765 déposé le 13 octobre 2006i>
Une erreur s'est produite lors du dépôt enregistré en date du 13 octobre 2006 sous la référence L060109765. En
effet, la dénomination de l'associé unique est Gresham Real Estate Fund II, L.P. et non JERSEY GRESHAM REAL ESTATE
FUND II, L.P..
Toutes les autres dispositions de la publication restent inchangées.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 juillet 2014.
Gresham Borehamwood IP S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2014103208/17.
(140121652) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2014.
89680
L
U X E M B O U R G
Zencap Global S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 21.911,00.
Siège social: L-2324 Luxembourg, 7, avenue J.P. Pescatore.
R.C.S. Luxembourg B 180.880.
In the year two thousand and fourteen, on the fourteenth day of May.
before us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
1. Global Fin Tech Holding S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing
under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
(Registre de Commerce et des Sociétés) under number B 184.665, having its registered office at 7, avenue J.P. Pescatore,
L-2324 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (hereinafter “Global Fin Tech Holding”),
being the holder of twelve thousand four hundred ninety-nine (12,499) common shares and five thousand (5,000) series
A shares,
here represented by Ms Alix van der Wielen, maître en droit, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a
proxy, given in Berlin, Germany, 17 April 2014, and in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 16 April 2014;
2. Bambino 53. V V UG (haftungsbeschränkt), a limited liability company (Unternehmergesellschaft (haftungsbes-
chränkt)) existing under the laws of Germany registered with the commercial register at the local court of Charlottenburg,
Germany, under number HRB 126893 B, having its registered address at Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Germany
(hereinafter “Bambino 53. V V”),
being the holder of one (1) common share,
here represented by Ms Alix van der Wielen, maître en droit, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a
proxy, given in Berlin, Germany, on 17 April 2014;
3. AI Zencap Holdings LLC, a limited liability company under the laws of the State of Delaware, United States of
America, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under registration number 5227608, with its
registered office at c/o Corporation Services Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808,
United States of America (hereinafter “Access”),
being the holder of three thousand six hundred twenty-five (3,625) series A shares, and becoming the holder of seven
hundred eighty-six (786) series B shares,
here represented by Ms Alix van der Wielen, maître en droit, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a
proxy, given in New York, United States of America, on 8 May 2014.
The said proxies, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary will remain annexed
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing parties are all the shareholders of the Company, representing the entire share capital of Zencap Global
S.à r.l. (the “Company”), a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg, having its registered office at 7, avenue J.P. Pescatore, L-2324 Luxembourg, registered with the Luxem-
bourg Trade and Companies’ Register under number B 180.880 and incorporated pursuant to a deed of the notary Maître
Carlo Wersandt, residing in Luxembourg, on 27 September 2013, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et
Associations number 2968 dated 25 November 2013. The articles of association were amended for the last time pursuant
to a deed of the notary Henri Hellinckx residing in Luxembourg on 14 May 2014, not yet published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations.
The appearing parties representing the entire share capital declare having waived any notice requirement, the general
meeting of shareholders is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the following agenda:
<i>Agendai>
1. Decision to create one (1) additional class of shares, referred to as the series B shares (hereinafter “Series B Shares”),
with a nominal value of one euro (EUR 1) each, and to hence have three (3) classes of shares in total, divided into common
shares, series A shares and Series B Shares.
2. Increase of the Company’s share capital by an amount of seven hundred eighty-six euro (EUR 786) so as to raise it
from its current amount of twenty-one thousand one hundred twenty-five euro (EUR 21,125) up to twenty-one thousand
nine hundred eleven euro (EUR 21,911) by issuing seven hundred eighty-six (786) Series B Shares with a nominal value
of one euro (EUR 1) each.
3. Subsequent amendment of article five point one (5.1) of the articles of association of the Company so that it shall
henceforth read as follows:
“ Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company’s share capital is set at twenty-one thousand nine hundred eleven euro (EUR 21,911), represented
by
89681
L
U X E M B O U R G
5.1.1 twelve thousand five hundred (12,500) common shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each (hereinafter
“Common Shares”),
5.1.2 eight thousand six hundred twenty-five (8,625) series A shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each
(hereinafter “Series A Shares”), and
5.1.3 seven hundred eighty-six (786) series B shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each (hereinafter “Series
B Shares”, the Series A Shares and Series B Shares hereinafter also referred to as “Preferred Shares”).
The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by these
articles of association or by the Law.”
4. Amendment of article eight (8) of the articles of association of the Company so that it shall henceforth read as
follows:
“ Art. 8. Liquidation and sale preferences.
8.1 In case (i) of any sale of at least fifty percent (50%) of all shares in the Company, or a swap or a take-over of the
Company in an economically comparable way in a single or more related transactions or in close time proximity to one
another, or (ii) of the liquidation of the Company or (iii) of any sale or transfer of shares in the Company either to third
parties or other shareholders that would result in either more than fifty percent (50%) of the share capital or more than
fifty percent (50%) of the voting rights being owned by the acquiring party/parties (change of control) as a result of one
or more related acquisitions, (each of the events described in (i), (ii) and (iii) is hereinafter referred to as a “Liquidity
Event”), the proceeds (“Exit Proceeds”) - subject to Article 8.2 through Article 8.3 below - will be distributed in accor-
dance with Article 8.4 to the shareholders pro rata corresponding to their participation in the Liquidity Event.
8.2 On a first level (“First Level”) the holders of Series B Shares shall receive an amount which equals the amount of
their respective total investment made in the Company (consisting of the nominal amount of the Series B Shares acquired
by that holder and any share premium and/or other capital contribution (account 115) paid by that holder to the Com-
pany). If the Exit Proceeds do not suffice for the payments to be made on the First Level, the Exit Proceeds shall be
allocated to the holders of Series B Shares pro rata to the amounts that would have been allocated to the holders of
Series B Shares on the First Level if the Exit Proceeds were sufficient.
8.3 On a second level (“Second Level”) the holders of Series A Shares shall receive an amount which equals the amount
of their respective total investment made in the Company (consisting of the nominal amount of the Series A Shares
acquired by that holder and any share premium and/or other capital contribution (account 115) paid by that holder to
the Company). If the Exit Proceeds do not suffice for the payments to be made on the Second Level, the Exit Proceeds
shall be allocated to the holders of Series A Shares pro rata to the amounts that would have been allocated to the holders
of Series A Shares on the Second Level if the Exit Proceeds were sufficient.
8.4 After the payments on the First and the Second Level have been made, the remaining Exit Proceeds shall be allocated
on a common level (“Common Level”) to all shareholders pro rata corresponding to their participation in the Liquidity
Event. Any amounts received by any shareholder on the First and the Second Level shall reduce the amount to be allocated
to such shareholder on the Common Level and shall be allocated subsequently pursuant to this Common Level provided
that no shareholder shall be obliged to repay any amount received on the First and the Second Level. The allocation at
the Common Level shall be made until all Exit Proceeds have been distributed to the shareholders. Irrespective of whether
or not the sale of shares is made in one Liquidity Event or after the Liquidity Event in one transaction or more transactions
no shareholder shall receive for the sale of all of its shares (and shall repay any exceeding amount to the other share-
holders) an amount exceeding the higher of (i) its share in the total Exit Proceeds or proceeds pro rata to the shares
sold on a common equivalent basis or (ii) the amount of its investment in the Company in respect of the shares sold. All
rights related to the liquidity preference stipulated herein can only be exercised once.
8.5 The preferred allocation on the First and the Second Level applies to each of the respective Preferred Shares as
long as on the respective Preferred Shares the respective amount stipulated in Article 8.2 has not yet been distributed
once.”
5. Miscellaneous.
Having duly considered each item of the agenda, the general meeting of shareholders unanimously takes the following
resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting of shareholders decides to create one (1) additional class of shares, referred to as the series B
shares (hereinafter “Series B Shares”), with a nominal value of one euro (EUR 1) each, and to hence have three (3) classes
of shares in total, divided into common shares, series A shares and Series B Shares.
<i>Second resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves to increase the share capital of the Company by an amount of seven
hundred eighty-six euro (EUR 786) so as to raise it from its current amount of twenty-one thousand one hundred twenty-
five euro (EUR 21,125) up to twenty-one thousand nine hundred eleven euro (EUR 21,911) by issuing seven hundred
eighty-six (786) Series B Shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.
89682
L
U X E M B O U R G
<i>Subscriptioni>
The seven hundred eighty-six (786) Series B Shares have been duly subscribed by Access, aforementioned, here re-
presented as aforementioned, for the price of seven hundred eighty-six euro (EUR 786).
<i>Paymenti>
The seven hundred eighty-six (786) Series B Shares subscribed by Access, aforementioned, have been entirely paid up
through a contribution in cash in an amount of seven hundred eighty-six euro (EUR 786).
The amount of seven hundred eighty-six euro (EUR 786) is as now available to the Company as has been proved to
the undersigned notary.
The contribution in the amount of seven hundred eighty-six euro (EUR 786) is entirely allocated to the share capital.
<i>Third resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves the amendment of article five point one (5.1) of the articles of association
of the Company so that it shall now henceforth read as follows:
“ Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company’s share capital is set at twenty-one thousand nine hundred eleven euro (EUR 21,911), represented
by
5.1.1 twelve thousand five hundred (12,500) common shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each (hereinafter
“Common Shares”),
5.1.2 eight thousand six hundred twenty-five (8,625) series A shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each
(hereinafter “Series A Shares”), and
5.1.3 seven hundred eighty-six (786) series B shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each (hereinafter “Series
B Shares”, the Series A Shares and Series B Shares hereinafter also referred to as “Preferred Shares”).
The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by these
articles of association or by the Law.”
<i>Fourth resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves to amend article eight (8) of the articles of association of the Company
so that it shall henceforth read as set out in the agenda of the present deed.
There being no further business, the meeting is closed.
<i>Costs and expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are
estimated at approximately EUR 2,500.-
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-
ment.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,
the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing parties
and in case of divergence between the English and the German text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name
and residence, the said proxyholder signed together with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:
Im Jahre zweitausendvierzehn, am vierzehnten Mai.
vor uns, dem unterzeichnenden Notar Maître Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxem-
burg.
SIND ERSCHIENEN:
1. Global Fin Tech Holding S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) ge-
gründet und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handelsund
Gesellschaftsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) unter der Nummer B 184.665, mit Sitz in 7, avenue J.P.
Pescatore, L-2324 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg („Global Fin Tech Holding“),
Inhaber von zwölftausendvierhundertneunundneunzig (12.499) Stammanteilen und fünftausend (5.000) Anteilen der
Serie A,
hier vertreten durch Frau Alix van der Wielen, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht
ausgestellt am 17. April 2014 in Berlin, Deutschland und am 16. April 2014 in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg;
2. Bambino 53. V V UG (haftungsbeschränkt), eine Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) bestehend unter
deutschem Recht, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland, unter der Nummer
HRB 126893 B, mit Sitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Deutschland („Bambino 53. V V“),
89683
L
U X E M B O U R G
Inhaber eines (1) Stammanteils,
hier vertreten durch Frau Alix van der Wielen, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht
vom 17. April 2014, ausgestellt in Berlin, Deutschland;
3. Al Zencap Holdings LLC, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (limited liability company) nach dem Recht des
Bundesstaates Delaware, Vereinigte Staaten von Amerika, eingetragen beim Secretary of State des Bundesstaates Dela-
ware unter der Eintragungsnummer 5227608, mit Sitz in c/o Corporation Services Company, 2711 Centerville Road,
Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, Vereinigte Staaten von Amerika („Access“),
Inhaber von dreitausendsechshundertfünfundzwanzig (3.625) Anteilen der Serie A und zukünftiger Inhaber von sie-
benhundertsechsundachtzig (786) Anteilen der Serie B,
hier vertreten durch Frau Alix van der Wielen, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht
vom 8. Mai 2014, ausgestellt in New York, Vereinte Staaten von Amerika.
Besagte Vollmachten, welche von der Bevollmächtigten der erschienenen Parteien und dem Notar ne varietur para-
phiert wurden, werden der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.
Die besagten erschienenen Parteien sind alle Gesellschafter der Gesellschaft und vertreten das gesamte Gesellschafts-
kapital der Zencap Global S.à r.l. (die „Gesellschaft”), einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité
limitée), gegründet und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 7, avenue J.P. Pescatore,
L-2324 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 180.880, ge-
gründet am 27. September 2013 gemäß einer Urkunde des Notars Maître Carlo Wersandt, mit Amtssitz in Luxemburg,
welche am 25. November 2013 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 2968 veröffentlicht wurde.
Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt am 14. Mai 2014 gemäß einer Urkunde des Notars Henri Hellinckx, mit
Amtssitz in Luxemburg, geändert, welche noch nicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht
wurde.
Da die erschienenen Parteien das gesamte Gesellschaftskapital vertreten und auf jegliche Ladungsformalitäten ver-
zichtet haben, ist die Gesellschafterversammlung ordnungsgemäß zusammengekommen und kann wirksam über alle
Punkte der folgenden Tagesordnung verhandeln:
<i>Tagesordnungi>
1. Beschluss bezüglich der Schaffung einer (1) weiteren Klasse von Anteilen, die als Anteile der Serie B bezeichnet
werden (die „Anteile der Serie B“) mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Anteil, wodurch nunmehr
insgesamt drei (3) Anteilsklassen bestehen, aufgeteilt in Stammanteile, Anteile der Serie A und Anteile der Serie B.
2. Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von einundzwanzigtausendein-
hundertfünfundzwanzig Euro (EUR 21.125) um einen Betrag von siebenhundertsechsundachtzig Euro (EUR 786) auf einen
Betrag von einundzwanzigtausendneunhundertelf Euro (EUR 21.911) durch die Ausgabe von siebenhundertsechsundacht-
zig (786) Anteilen der Serie B mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Anteil.
3. Anschließende Änderung des Artikels fünf Punkt eins (5.1) der Satzung der Gesellschaft, welcher nunmehr wie folgt
lautet:
„ Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt einundzwanzigtausendneunhundertelf Euro (EUR 21.911), beste-
hend aus
5.1.1 zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteilen mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Anteil
(die „Stammanteile”),
5.1.2 achttausendsechshundertfünfundzwanzig (8.625) Anteilen der Serie A mit einem Nominalwert von einem Euro
(EUR 1) pro Anteil (die „Anteile der Serie A”), und
5.1.3 siebenhundertsechsundachtzig (786) Anteilen der Serie B mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro
Anteil (die „Anteile der Serie B”, wobei die Anteile der Serie A und die Anteile der Serie B auch als „Vorzugsanteile“
bezeichnet werden).
Die mit den Anteilen verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es wird in dieser Satzung oder
durch das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.“
4. Änderung des Artikels acht (8) der Satzung der Gesellschaft, welcher nunmehr wie folgt lautet:
„ Art. 8. Liquidations- und Verkaufspräferenzen.
8.1 Im Falle (i) eines Verkaufs von mindestens fünfzig Prozent (50%) aller Anteile an der Gesellschaft oder eines
Tausches oder einer Übernahme der Gesellschaft in wirtschaftlich vergleichbarer Weise in einer oder mehreren Trans-
aktionen oder in zeitlicher Nähe zueinander, oder (ii) der Liquidation der Gesellschaft oder (iii) des Verkaufs oder der
Übertragung von Anteilen an der Gesellschaft entweder an Dritte oder an andere Gesellschafter, was dazu führen würde,
dass entweder mehr als fünfzig Prozent (50%) des Gesellschaftskapitals oder mehr als fünfzig Prozent (50%) der Stimm-
rechte im Besitz der erwerbenden Partei bzw. Parteien wären (change of control), als Ergebnis eines oder mehrerer
verbundener Akquisitionen, (wobei jeder der unter (i), (ii) und (iii) beschriebenen Fälle im Folgenden als „Liquiditätser-
89684
L
U X E M B O U R G
eignis“ bezeichnet wird), werden die Erlöse („Exiterlöse“) - vorbehaltlich der Artikel 8.2 bis 8.3 - im Einklang mit Artikel
8.4 auf einer pro rata-Basis entsprechend ihrer Beteiligung am Liquiditätsereignis an die Gesellschafter verteilt.
8.2 Auf einer ersten Ebene („Erste Ebene”) erhalten die Inhaber von Anteilen der Serie B einen Betrag, welcher dem
Betrag ihrer jeweiligen Gesamtinvestition in die Gesellschaft entspricht (bestehend aus dem Nominalbetrag der von
diesem Inhaber erworbenen Anteile der Serie B und dem Agio und/oder anderen Kapitaleinlage (Konto 115 des Stan-
dardisierten Luxemburgischen Kontenplans), die von diesem Inhaber an die Gesellschafter gezahlt wurden). Sind nicht
ausreichend Exiterlöse für die Zahlungen auf der Ersten Ebene vorhanden, so werden die Exiterlöse an die Inhaber der
Anteile der Serie B auf einer pro-rata Basis zu den Beträgen verteilt, die an die Inhaber der Anteile der Serie B auf der
Ersten Ebene verteilt worden wären, wenn ausreichend Exiterlöse vorhanden gewesen wären.
8.3 Auf einer zweiten Ebene („Zweite Ebene”) erhalten die Inhaber von Anteilen der Serie A einen Betrag, welcher
dem Betrag ihrer jeweiligen Gesamtinvestition in die Gesellschaft entspricht (bestehend aus dem Nominalbetrag der von
diesem Inhaber erworbenen Anteile der Serie A und dem Agio und/oder anderen Kapitaleinlage (Konto 115 des Stan-
dardisierten Luxemburgischen Kontenplans), die von diesem Inhaber an die Gesellschafter gezahlt wurden). Sind nicht
ausreichend Exiterlöse für die Zahlungen auf der Zweiten Ebene vorhanden, so werden die Exiterlöse an die Inhaber der
Anteile der Serie A auf einer pro-rata Basis zu den Beträgen verteilt, die an die Inhaber der Anteile der Serie A auf der
Zweiten Ebene verteilt worden wären, wenn ausreichend Exiterlöse vorhanden gewesen wären.
8.4 Nachdem die Zahlungen auf der Ersten und auf der Zweiten Ebene geleistet wurden, werden die übrigen Exiterlöse
auf einer gemeinsamen Ebene („Gemeinsame Ebene“) an alle Gesellschafter auf einer pro rata-Basis entsprechend ihrer
Beteiligung am Liquiditätsereignis verteilt. Sämtliche von einem Gesellschafter auf der Ersten und auf der Zweiten Ebene
erhaltenen Beträge mindern den von diesem Gesellschafter zu erhaltenden Betrag auf der Gemeinsamen Ebene und
werden anschließend entsprechend dieser Gemeinsamen Ebene zugeteilt, mit der Maßgabe, dass kein Gesellschafter zur
Rückzahlung eines auf der Ersten und auf der Zweiten Ebene erhaltenen Betrags verpflichtet ist. Die Zuteilung auf der
Gemeinsamen Ebene erfolgt solange, bis alle Exiterlöse an die Gesellschafter verteilt wurden. Unabhängig davon, ob der
Verkauf von Anteilen während eines Liquiditätsereignisses oder danach in einer oder mehreren Transaktionen erfolgt
oder nicht, hat kein Gesellschafter für den Verkauf all seiner Anteile einen Betrag zu erhalten (und übersteigende Beträge
an die anderen Gesellschafter zurückzuzahlen), der höher ist, (i) als sein Anteil an der Gesamtheit der Exiterlöse oder
Erlöse auf einer pro rata-Basis zu den Anteilen, die auf einer gemeinsamen und gleichwertigen Basis verkauft wurden oder
(ii) als der Betrag seiner Investition in die Gesellschaft hinsichtlich der verkauften Anteile. Sämtliche mit der hierin fest-
gelegten Liquiditätspräferenz verbundenen Rechte können nur einmal ausgeübt werden.
8.5 Die bevorzugte Zuteilung auf der Ersten und auf der Zweiten Ebene gilt für alle entsprechenden Vorzugsanteile
solange, wie bei den jeweiligen Vorzugsanteilen der jeweils in Artikel 8.2 festgelegte Betrag noch nicht verteilt wurde.“
5. Verschiedenes.
Nach ordnungsgemäßer Prüfung jedes Tagesordnungspunkts fasst die Gesellschafterversammlung einstimmig die fol-
genden Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt, eine (1) weitere Klasse von Anteilen zu schaffen, die als Anteile der Serie
B bezeichnet werden (die „Anteile der Serie B“) mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Anteil, wodurch
nunmehr insgesamt drei (3) Anteilsklassen bestehen, aufgeteilt in Stammanteile, Anteile der Serie A und Anteile der Serie
B.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt, das Gesellschaftskapital der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von
einundzwanzigtausendeinhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 21.125) um einen Betrag von siebenhundertsechsundachtzig
Euro (EUR 786) auf einen Betrag von einundzwanzigtausendneunhundertelf Euro (EUR 21.911) durch die Ausgabe von
siebenhundertsechsundachtzig (786) Anteilen der Serie B mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Anteil,
zu erhöhen.
<i>Zeichnungi>
Die siebenhundertsechsundachtzig (786) Anteile der Serie B wurden ordnungsgemäß von Access, vorbenannt, hier
vertreten wie vorerwähnt, zu einem Preis von siebenhundertsechsundachtzig Euro (EUR 786) gezeichnet.
<i>Zahlungi>
Die von Access, vorbenannt, gezeichneten siebenhundertsechsundachtzig (786) Anteile der Serie B wurden vollständig
eingezahlt durch eine Bareinlage in Höhe von siebenhundertsechsundachtzig Euro (EUR 786).
Die Summe von siebenhundertsechsundachtzig Euro (EUR 786) steht der Gesellschaft ab sofort zur freien Verfügung,
so wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde.
Die Einlage in Höhe von siebenhundertsechsundachtzig Euro (EUR 786) wird vollständig dem Gesellschaftskapital
zugeführt.
89685
L
U X E M B O U R G
<i>Dritter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt, Artikel fünf Punkt eins (5.1) der Satzung der Gesellschaft zu ändern, welcher
nunmehr wie folgt lautet:
„ Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt einundzwanzigtausendneunhundertelf Euro (EUR 21.911), beste-
hend aus
5.1.1 zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteilen mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Anteil
(die „Stammanteile”),
5.1.2 achttausendsechshundertfünfundzwanzig (8.625) Anteilen der Serie A mit einem Nominalwert von einem Euro
(EUR 1) pro Anteil (die „Anteile der Serie A”), und
5.1.3 siebenhundertsechsundachtzig (786) Anteilen der Serie B mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro
Anteil (die „Anteile der Serie B”, wobei die Anteile der Serie A und die Anteile der Serie B auch als „Vorzugsanteile“
bezeichnet werden).
Die mit den Anteilen verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es wird in dieser Satzung oder
durch das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.“
<i>Vierter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt, Artikel acht (8) der Satzung der Gesellschaft zu ändern, welcher nunmehr
wie in der Tagesordnung der vorliegenden Urkunde dargestellt lautet.
Da die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung geschlossen.
<i>Kosten und Auslageni>
Die Kosten, Auslagen, Honorare und Gebühren jeglicher Art, die von der Gesellschaft zu tragen sind, werden auf
ungefähr EUR 2.500,- geschätzt.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg am eingangs erwähnten Datum.
Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache beherrscht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende
Urkunde auf Verlangen der erschienenen Parteien auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung;
auf Verlangen besagter erschienener Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen
Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.
Die vorstehende Urkunde ist der Bevollmächtigten der erschienenen Parteien, welche dem Notar mit Namen, Vorn-
amen und Wohnsitz bekannt ist, verlesen und vom Notar gemeinsam mit dieser Bevollmächtigten unterzeichnet worden.
Gezeichnet: A. VAN DER WIELEN und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 mai 2014. Relation: LAC/2014/24019. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - Der Gesellschaft auf Begehr erteilt.
Luxemburg, den 27. Juni 2014.
Référence de publication: 2014092502/314.
(140108842) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juillet 2014.
I-Space S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1650 Luxembourg, 10, avenue Guillaume.
R.C.S. Luxembourg B 165.013.
Par la présente, il est déclaré lors de la réunion extraordinaire du 09.05.2014, que les parts de M. MEYER Alec (34%)
et de M. PIZZOLANTE Antonio (33%) ont été cédés à M. SENHADJI Tewfik qui détient désormais 100 % des parts
sociales de la société i-Space sarl.
Il y a lieu de noter que M PIZZOLANTE Antonio n'est plus gérant administratif de la société et que M. SENHADJI
Tewfik devient gérant unique de la société et a le pouvoir de signature individuelle.
Fait à Luxembourg, le 12.05.2014.
Po i-Space sarl
T. SENHADJI
<i>Gérant techniquei>
Référence de publication: 2014068606/16.
(140079410) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2014.
89686
L
U X E M B O U R G
Largam S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1230 Luxembourg, 7, rue Jean Bertels.
R.C.S. Luxembourg B 134.808.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour LARGAM S.A.i>
Référence de publication: 2014067626/10.
(140079353) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2014.
Luxembourg Contact Centers S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 70.500.000,00.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 26.357.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
LUXEMBOURG CONTACT CENTERS Sàrl
Société à Responsabilité Limitée
Référence de publication: 2014067624/11.
(140079038) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2014.
VCK Lease S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 188.250.
STATUTES
In the year two thousand and fourteen, on the nineteenth day of June.
Before us, Maître Henri Hellinckx notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
There appeared the following:
VCK Lease Stichting, a foundation organised under the laws of The Netherlands with its official seat in Amsterdam,
and its place of business at Strawinskylaan 411, 1077 XX Amsterdam, the Netherlands;
represented by Mr Régis Galiotto, notary’s clerk, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in
Amsterdam, the Netherlands on June 19, 2014.
The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed
to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the officiating notary to enact the deed of
incorporation of a public limited company (société anonyme) which it wishes to incorporate with the following articles
of association:
Chapter I. - Form, Name, Registered office, Object, Duration
Art. 1. Form, Name. There is established a public limited company (société anonyme) (the “Company”) governed by
the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles
of association.
The Company will exist under the name “VCK Lease S.A.”
Art. 2. Registered office. The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg.
Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of directors.
It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general
meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of
the board of directors.
In the event that the board of directors determines that extraordinary political, economic or social circumstances or
natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
89687
L
U X E M B O U R G
traordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwiths-
tanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.
Art. 3. Object. The object of the Company is the financing, leasing and remarketing of a Boeing, model 747-8F aircraft,
MSN 38078 (the "Aircraft") and to undertake or procure to undertake any such other actions, matters or things as may
be necessary to achieve, or which are incidental or conductive to, any of the above purposes.
In order to accomplish its purpose, the Company may acquire, lease and sell the Aircraft and finance such acquisition
through notes, loans or other financial arrangements, in whatever form, and issue guarantees and grant any form of
security interest or other liens over its assets, including mortgages and pledges, to secure the financing obligations entered
into by the Company or by Cargolux Airlines International S.A. in its capacity as lessee and operator of the Aircraft with
respect to the acquisition, financing or leasing of the Aircraft.
The Company may further issue guarantees, and grant any form of security interest or other liens over its assets,
including mortgages and pledges, to secure any indebtedness now or hereafter and directly or indirectly owing to Export-
Import Bank of the United States (“Ex-Im Bank”) or to any agent or trustee acting for Ex-Im Bank or to any person or
entity who is the beneficiary, directly or indirectly, of any past, present or future guarantee by Ex-Im Bank (but only to
the extent such indebtedness, if not owed to Ex-Im Bank, is guaranteed by Ex-Im Bank), from any of (i) Cargolux Airlines
International S.A.; (ii) any affiliate of Cargolux Airlines International S.A.; (iii) any special purpose company arranged in
part by Cargolux Airlines International S.A.; or (iv) any other person or entity to the extent that Cargolux Airlines
International S.A., any affiliate thereof or any such special purpose company is obligated to pay or reimburse such other
person or entity for such indebtedness or has agreed to guarantee such indebtedness.
The Company may for the sole purpose of financing the acquisition of the Aircraft raise funds especially through
borrowing in any form or by issuing any kind and under any method or form of notes, securities or debt instruments,
bonds and debentures and generally issue securities of any type in any jurisdiction.
Art. 4. Duration. The Company is incorporated for an unlimited period of time.
It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
Chapter II. - Share capital, Shares
Art. 5. Issued capital. The issued capital of the Company is set at fifty thousand United States Dollars (USD 50,000.-),
represented by fifty thousand (50,000) shares without mention of a nominal value.
The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association or as set out in article 6 hereof.
Any new shares to be paid for in cash shall be offered by preference to the existing shareholder(s). In case of plurality
of shareholders, such shares shall be offered to the shareholders in proportion to the number of shares held by them in
the Company’s share capital. The board of directors shall determine the period of time during which such preferential
subscription right may be exercised and which may not be less than thirty (30) days from the date of dispatch of a registered
letter sent to the shareholder(s) announcing the opening of the subscription period.
The general meeting of shareholders may limit or suppress the preferential subscription right of the existing share-
holder(s) in the manner required for an amendment of these articles of association.
The Company may redeem its own shares subject to the provisions of the Law.
Art. 6. Shares. The Company’s share capital is divided into shares, each of them having the same accounting par value.
The shares of the Company are and shall remain in registered form.
The shares shall be issued in uncertificated form unless specifically requested by the shareholders.
The Company may have one or several shareholders.
Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of the
shareholders shall not cause the dissolution of the Company.
Art. 7. Register of shares - Transfer of shares. A register of shares shall be kept at the registered office of the Company,
where it shall be available for inspection by any shareholder. This register shall contain all the information required by
the Law. Ownership of shares is established by registration in said share register. Evidence of such registration shall be
provided upon request and at the expense of the relevant shareholder.
The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall appoint
a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend the
exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.
The shares are freely transferable in accordance with the provisions of the law.
Any transfer of registered shares shall become effective towards the Company and third parties either (i) through the
recording of a declaration of transfer into the register of shares, signed and dated by the transferor and the transferee
or their representatives, or (ii) upon notification of the transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company.
89688
L
U X E M B O U R G
Chapter III. - General meetings of shareholders
Art. 8. Powers of the general meeting of shareholders. The shareholders exercise their collective rights in the general
meeting of shareholders. Any regularly constituted general meeting of shareholders of the Company shall represent the
entire body of shareholders of the Company. The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly
reserved to it by the Law and by these articles of association.
If the Company has only one shareholder, any reference made herein to the “general meeting of shareholders” shall
be construed as a reference to the “sole shareholder”, depending on the context and as applicable and powers conferred
upon the general meeting of shareholders shall be exercised by the sole shareholder.
Art. 9. Convening of general meetings of shareholders. The general meeting of shareholders of the Company may at
any time be convened by the board of directors or, as the case may be, by the internal auditor(s).
It must be convened by the board of directors or the internal auditor(s) upon written request of one or several
shareholders representing at least ten percent (10%) of the Company's share capital. In such case, the general meeting
of shareholders shall be held within a period of one (1) month from the receipt of such request.
The convening notice for every general meeting of shareholders shall contain the date, time, place and agenda of the
meeting and shall be sent to the shareholders at their address as recorded in the share register, with a minimum interval
of eight (8) days, and eight (8) days before the meeting.
If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived any convening
requirement, the meeting may be held without prior notice or publication.
Art. 10. Conduct of general meetings of shareholders. The annual general meeting of shareholders shall be held in
Luxembourg at the registered office of the Company or at such other place in Luxembourg as may be specified in the
convening notice of such meeting, on May 5 at 10 o'clock. If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall
be held on the next following business day. Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may
be specified in the respective convening notices.
A board of the meeting shall be formed at any general meeting of shareholders, composed of a chairman, a secretary
and a scrutineer, who need neither be shareholders, nor members of the board of directors. If all the shareholders present
at the general meeting decide that they can control the regularity of the votes, the shareholders may unanimously decide
to only appoint (i) a chairman and a secretary or (ii) a single person who will assume the role of the board and in such
case there is no need to appoint a scrutineer. Any reference made herein to the “board of the meeting” shall in such case
be construed as a reference to the “chairman and secretary” or, as the case may be to the “single person who assumes
the role of the board”, depending on the context and as applicable. The board of the meeting shall especially ensure that
the meeting is held in accordance with applicable rules and, in particular, in compliance with the rules in relation to
convening, majority requirements, vote tallying and representation of shareholders.
An attendance list must be kept at any general meeting of shareholders.
A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or
by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. One person may represent several or even all
shareholders.
Shareholders taking part in a meeting by conference call, through video conference or by any other means of com-
munication allowing their identification and allowing that all persons taking part in the meeting hear one another on a
continuous basis and allowing an effective participation of all such persons in the meeting, are deemed to be present for
the computation of the quorums and votes, subject to such means of communication being made available at the place
of the meeting.
Each shareholder may vote at a general meeting through a signed voting form sent by post, electronic mail, facsimile
or any other means of communication to the Company’s registered office or to the address specified in the convening
notice. The shareholders may only use voting forms provided by the Company which contain at least the place, date and
time of the meeting, the agenda of the meeting, the proposal submitted to the shareholders, as well as for each proposal
three boxes allowing the shareholder to vote in favour thereof, against, or abstain from voting by ticking the appropriate
box.
Voting forms which, for a proposed resolution, do not show only (i) a vote in favour or (ii) a vote against the proposed
resolution or (iii) an abstention are void with respect to such resolution. The Company shall only take into account voting
forms received prior to the general meeting which they relate to.
Art. 11. Quorum and vote. Each share entitled to one vote in general meetings of shareholders.
Except as otherwise required by the Law or these articles of association, resolutions at a general meeting of share-
holders duly convened shall not require any presence quorum and shall be adopted at a simple majority of the votes
validly cast regardless of the portion of capital represented. Abstentions and nil votes shall not be taken into account.
Art. 12. Amendments of the articles of association. Except as otherwise provided herein, these articles of association
may be amended by a majority of at least two thirds of the votes validly cast at a general meeting at which a quorum of
more than half of the Company’s share capital is present or represented. If no quorum is reached in a meeting, a second
89689
L
U X E M B O U R G
meeting may be convened in accordance with the Law and these articles of association which may deliberate regardless
of the quorum and at which resolutions are taken at a majority of at least two-thirds of the votes validly cast. Abstentions
and nil votes shall not be taken into account.
Art. 13. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.
Art. 14. Adjournment of general meeting of shareholders. Subject to the provisions of the Law, the board of directors
may adjourn any general meeting of shareholders which is in progress for four (4) weeks. The board of directors shall
do so at the request of shareholders representing at least twenty percent (20%) of the share capital of the Company. In
the event of an adjournment, any resolution already adopted by the general meeting of shareholders shall be cancelled.
Art. 15. Minutes of general meetings of shareholders. The board of any general meeting of shareholders shall draw up
minutes of the meeting which shall be signed by the members of the board of the meeting as well as by any shareholder
upon its request.
Any copy and excerpt of such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any third
party, shall be certified as a true copy of the original by the notary having had custody of the original deed, in case the
meeting has been recorded in a notarial deed, or shall be signed by the chairman of the board of directors or by any two
of its members.
Chapter IV. - Management
Art. 16. Composition and powers of the board of directors. The Company shall be managed by a board of directors
composed of at least three (3) members. However, where the Company has been incorporated by a single shareholder
or where it appears at a shareholders’ meeting that all the shares issued by the Company are held by a sole shareholder,
the Company may be managed by a sole director until the next general meeting of shareholders following the increase
of the number of shareholders. In such case, to the extent applicable and where the term “sole director” is not expressly
mentioned in these articles of association, a reference to the “board of directors” used in these articles of association is
to be construed as a reference to the “sole director”.
The board of directors is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any actions
necessary or useful to fulfill the Company’s corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the Law
or by these articles of association to the general meeting of shareholders.
Art. 17. Daily management. The daily management of the Company as well as the representation of the Company in
relation with such daily management may, in accordance with article 60 of the Law, be delegated to one or more directors,
officers or other agents, acting individually or jointly. Their appointment, removal and powers shall be determined by a
resolution of the board of directors.
The Company may also grant special powers by notarised proxy or private instrument.
Art. 18. Appointment, removal and term of office of directors. The directors shall be appointed by the general meeting
of shareholders which shall determine their remuneration and term of office.
The term of office of a director may not exceed six (6) years and each director shall hold office until a successor is
appointed. Directors may be re-appointed for successive terms.
Each director is appointed by the general meeting of shareholders at a simple majority of the votes validly cast.
Any director may be removed from office at any time with or without cause by the general meeting of shareholders
at a simple majority of the votes validly cast.
If a legal entity is appointed as director of the Company, such legal entity must designate a private individual as per-
manent representative who shall perform this role in the name and on behalf of the legal entity. The relevant legal entity
may only remove its permanent representative if it appoints a successor at the same time. An individual may only be a
permanent representative of one (1) director of the Company and may not be a director of the Company at the same
time.
Art. 19. Vacancy in the office of a director. In the event of a vacancy in the office of a director because of death, legal
incapacity, bankruptcy, resignation or otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time
not exceeding the initial mandate of the replaced director by the remaining directors until the next meeting of shareholders
which shall resolve on the permanent appointment in compliance with the applicable legal provisions.
In case the vacancy occurs in the office of the Company’s sole director, such vacancy must be filled without undue
delay by the general meeting of shareholders.
Art. 20. Convening meetings of the board of directors. The board of directors shall meet upon call by the chairman,
or by any director. Meetings of the board of directors shall be held at the registered office of the Company unless
otherwise indicated in the notice of meeting.
Written notice of any meeting of the board of directors must be given to directors twenty-four (24) hours at least in
advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons
of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each director in
writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document being
89690
L
U X E M B O U R G
sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined
in a prior resolution adopted by the board of directors which has been communicated to all directors.
No prior notice shall be required in case all the members of the board of directors are present or represented at a
board meeting and waive any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all
members of the board of directors.
Art. 21. Conduct of meetings of the board of directors. The board of directors shall elect among its members a
chairman. It may also choose a secretary who does not need to be a director and who shall be responsible for keeping
the minutes of the meetings of the board of directors.
The chairman shall chair all meetings of the board of directors, but in his absence, the board of directors may appoint
another director as chairman pro tempore by vote of the majority of directors present at any such meeting.
Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing another director as his proxy in writing,
or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being sufficient
proof thereof. A director may represent one or more, but not all of the other directors.
Meetings of the board of directors may also be held by conference call or video conference or by any other means of
communication allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis and allowing
an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means shall be equivalent to a participation
in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.
The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors are present or represented
at a meeting of the board of directors.
Decisions shall be taken by a majority vote of the directors present or represented at such meeting. In the case of a
tie, the chairman shall have a casting vote.
Save as otherwise provided by the Law, any director who has, directly or indirectly, an interest in a transaction
submitted to the approval of the board of directors which conflicts with the Company’s interest, must inform the board
of directors of such conflict of interest and must have his declaration recorded in the minutes of the board meeting. The
relevant director may not take part in the discussions on and may not vote on the relevant transaction. Any such conflict
of interest must be reported to the next general meeting of shareholders prior to such meeting taking any resolution on
any other item.
Where the Company comprises a single director, transactions made between the Company and the director having
an interest conflicting with that of the Company is only mentioned in the resolution of the sole director.
The conflict of interest rules shall not apply where the decision of the board of directors or the sole director relates
to current operations entered into under normal conditions.
The board of directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each director may express his consent sepa-
rately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be the
date of the last signature.
Art. 22. Minutes of the meeting of the board of directors - Minutes of the decisions of the sole director. The minutes
of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chairman pro tempore,
or by any two (2) directors. Copies or excerpts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or
otherwise shall be signed by the chairman or by any two (2) directors.
Decisions of the sole director shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole director. Copies or
excerpts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the sole director.
Art. 23. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances by (i) the
signature of the sole director, or, if the Company has several directors, by the joint signature of any two (2) directors or
by (ii) the joint signatures or the sole signature of any person(s) to whom such power may have been delegated by the
board of directors within the limits of such delegation.
Within the limits of the daily management, the Company shall be bound towards third parties by the signature of any
person(s) to whom such power may have been delegated, acting individually or jointly in accordance within the limits of
such delegation.
Chapter V. - Audit and supervision
Art. 24. Auditor(s). The operations of the Company shall be supervised by one or several internal auditors (commis-
saire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint the internal auditor(s) and shall determine their term of office,
which may not exceed six (6) years.
An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting of
shareholders.
The internal auditors have an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
If the general meeting of shareholders of the Company appoints one or more independent auditor(s) (réviseur(s)
d’entreprises agréé(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies’
89691
L
U X E M B O U R G
register and the accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is
suppressed.
An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with his approval.
Chapter VI. - Financial year, Annual accounts, Allocation of profits, Interim dividends
Art. 25. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end
on the thirty-first of December of the same year.
Art. 26. Annual accounts and allocation of profits. At the end of each financial year, the accounts are closed and the
board of directors draws up an inventory of the Company’s assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss
accounts in accordance with the law.
From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve. This
allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten per
cent (10%) of the share capital of the Company.
Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the
contributing shareholder agrees with such allocation.
In case of a share capital reduction, the Company’s legal reserve may be reduced in proportion so that it does not
exceed ten per cent (10%) of the share capital.
Upon recommendation of the board of directors, the general meeting of shareholders shall determine how the re-
mainder of the Company’s profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.
Art. 27. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums. The board of directors may proceed to the
payment of interim dividends solely from the profits of the Company if any, subject to the provisions of the Law.
Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the shareholders
subject to the provisions of the Law and these articles of association.
Chapter VII. - Liquidation
Art. 28. Liquidation. In the event of dissolution of the Company in accordance with article 4 of these articles of
association, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting
of shareholders deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless other-
wise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the
liabilities of the Company.
Chapter VIII. - Final clause, Governing law
Art. 29. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance
with the Law.
<i>Transitional provisionsi>
1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 31 December
2014.
2. The first annual general meeting of shareholders shall be held in 2014.
3. Interim dividends may also be distributed during the Company’s first financial year.
<i>Subscription and paymenti>
The fifty thousand (50,000) shares issued have been subscribed by VCK Lease Stichting aforementioned, for the price
of 50,000 United States Dollars (USD 50,000.-).
The shares so subscribed have been fully paid-up by a contribution in cash so that the amount of fifty thousand United
States Dollars (USD 50,000) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Declarationi>
The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions provided for or referred to
in articles 26 of the Law and expressly states that they have been complied with.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be
borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately one thousand five hundred
Euros (1,500.- EUR).
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
The incorporating sole shareholder, representing the entire share capital of the Company and having waived any
convening requirements, has thereupon passed the following resolutions:
89692
L
U X E M B O U R G
1. The address of the registered office of the Company is set at 5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg;
2. Mr. Claude Crauser, born in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg on April 22, 1981, professionally residing
at 5, avenue Gaston Diderich, L-1420, Luxembourg is appointed as sole director of the Company until the general meeting
of shareholders convened to approve the Company’s annual accounts for the first financial year.
3. Grant Thornton Lux Audit S.A., a société anonyme incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,
having its registered office at 83 Pafebruch, L-8308 Capellen and registered with the Luxembourg Register of Commerce
and Companies under number B43.298, is appointed as independent auditor for a period ending at the annual shareholders
approving the annual accounts of the financial year ending on 31 December 2018.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified in the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,
this deed is worded in English followed by a French translation; at the request of the same appearing party and in case of
divergence between the English and the French text, the English version shall prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name
and residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française de ce qui précède:
L’an deux mille quatorze, le dix-neuf juin.
Par-devant nous Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
VCK Lease Stichting, une fondation existant selon les lois des Pays-Bas, ayant son siège social à Amsterdam, Pays-Bas
et dont l’adresse est Strawinskylaan 411, 1077 XX Amsterdam, Pays-Bas
dûment représentée par Mr Régis Galiotto, clerc de notaire, résidant professionnellement à Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée le 19 juin 2014 à Amsterdam, Pays-Bas.
Ladite procuration, paraphée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire, restera annexée au
présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d’enregistrement.
La partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser l’acte de consti-
tution d’une société anonyme qu’elle souhaite constituer avec les statuts suivants:
Chapitre I
er
. - Forme, Nom, Siège social
Art. 1
er
. Forme, Nom. Il est constitué une société anonyme (ci-après la «Société») régie par la loi du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), ainsi que par les présents statuts.
La Société existe sous le nom de “VCK Lease S.A.”
Art. 2. Siège social. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Le siège social pourra être transféré au sein de la même commune par décision du conseil d’administration. Il pourra
être transféré dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l’assemblée générale des
actionnaires, prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts.
Des succursales ou bureaux peuvent être créés, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l’étranger, par décision du
conseil d’administration.
Dans l’hypothèse où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique,
économique ou social ou des catastrophes naturelles se sont produits ou seraient imminents, de nature à interférer avec
l’activité normale de la Société à son siège social, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu'à
la cessation complète de ces circonstances exceptionnelles; ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur
la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.
Art. 3. Objet. L’objet de la Société est le financement, la location et la recommercialisation d’un Boeing, modèle 747-8F,
MSN 38078 (l’«Avion») et de faire ou faire faire toute autre action, procédure ou chose tels que nécessaires afin de
réaliser ou faisant, l’accomplissement de ces objectifs susmentionnés.
Afin d’accomplir son objet social, la Société peut acquérir, louer et vendre l’Avion et financer cette acquisition par des
obligations, prêts ou tout autre arrangement financier, sous quelque forme que ce soit, émettre des garanties et accorder
toute sorte de sûretés ou autres sur ses actifs, notamment des hypothèques, des gages, et de sécuriser les obligations de
financement contractées par la Société ou par Cargolux Airlines International S.A. en sa qualité de locataire et d’opérateur
de l’Avion dans le cadre de l’acquisition, du financement ou de la location de l’Avion.
La Société peut également émettre des garanties, et accorder toute forme de sûretés ou autres sur ses actifs, notam-
ment des hypothèques, des gages, afin de sécuriser toutes dettes dues maintenant ou plus tard, directement ou
indirectement, envers Export-Import Bank des Etats-Unis d’Amériques («Ex-Im Bank») ou tout agent ou fiduciaire agissant
pour Ex-Im Bank ou toute autre personne ou entité qui serait le bénéficiaire, direct ou indirect, de toutes garanties
passées, présentes ou futures émises par Ex-Im Bank (mais uniquement si ces dettes sont garanties par Ex-Im Bank et
non dues par Ex-Im Bank), par (i) Cargolux Airlines International S.A.; (ii) n’importe quelle fililale de Cargolux Airlines
89693
L
U X E M B O U R G
International S.A.; (iii) n’importe quel véhicule spécialisé en investissement détenu en partie par Cargolux Airlines Inter-
national S.A., ou (iv) toute autre personne ou entité dont Cargolux Airlines International S.A., toute filiale ou véhicule
spécialisé en investissement est tenu de payer ou rembourser cette autre personne ou entité pour une dette quelconque
ou a accepté de garantir cette dette.
La Société peut dans le seul but de financer l’acquisition de l’Avion lever des fonds, notamment en empruntant sous
quelque forme que ce soit ou en émettant toute sorte et sous toute forme possible, des obligations, des titres ou des
instruments de dettes, des obligations garanties ou non garanties, et d’une manière générale en émettant des valeurs
mobilières de tout type dans n’importe quelle juridiction.
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Elle pourra être dissoute à tout moment et sans cause par une décision de l’assemblée générale des actionnaires, prise
aux conditions requises pour une modification des présents statuts.
Chapitre II. - Capital social - Actions
Art. 5. Capital social. Le capital social de la Société est fixé à cinquante mille dollars américains (USD 50.000), représenté
par cinquante mille (50.000) actions sans désignation de valeur nominale.
Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit par une décision de l’assemblée générale des actionnaires
de la Société, prise aux conditions requises pour la modification des présents statuts ou dans les conditions prévues par
l’article 6.
Toutes nouvelles actions à libérer en numéraire doivent être offertes par préférence à (aux) (l’)actionnaire(s) existant
(s). En cas de pluralité d’actionnaires, ces actions sont offertes aux actionnaires en proportion du nombre d’actions qu’ils
détiennent dans le capital social de la Société. Le conseil d’administration doit déterminer la période au cours de laquelle
ce droit préférentiel de souscription pourra être exercé, qui ne peut être inférieure à trente (30) jours à compter de
l’envoi à chaque actionnaire d’une lettre recommandée annonçant l’ouverture de la période de souscription. L’assemblée
générale des actionnaires peut restreindre ou supprimer le droit préférentiel de souscription de (des) (l’)actionnaire(s)
existant(s) conformément aux dispositions applicables en matière de modification des statuts.
La Société peut racheter ses propres actions dans les conditions prévues par la Loi.
Art. 6. Actions. Le capital social de la Société est divisé en actions ayant chacune le même pair comptable.
Les actions de la Société sont et resteront nominatives. Les actions ne seront pas émises sous forme de certificat sauf
demande expresse des actionnaires.
La Société peut avoir un ou plusieurs actionnaires.
Le décès, la suspension des droits civils, la dissolution, la liquidation, la faillite ou l’insolvabilité ou tout autre événement
similaire concernant un actionnaire n’entraîne pas la dissolution de la Société.
Art. 7. Registre des actions - Transfert des actions. Un registre des actions sera tenu au siège social de la Société, où
il sera mis à disposition de chaque actionnaire pour consultation. Ce registre devra contenir toutes les informations
requises par la Loi. Des attestations de cette inscription seront fournies sur demande et aux frais de l’actionnaire de-
mandeur.
La Société ne reconnaît qu'un seul titulaire par action. Les copropriétaires indivis devront désigner un représentant
unique qui les représentera vis-à-vis de la Société. La Société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits
attachés à cette action, jusqu'à ce qu'un tel représentant ait été désigné.
Les actions sont librement cessibles dans les conditions prévues par la Loi.
Tout transfert d’actions nominatives deviendra opposable à la Société et aux tiers soit (i) sur inscription d’une décla-
ration de cession dans le registre des actionnaires, signée et datée par le cédant et le cessionnaire ou leurs représentants,
ou (ii) sur notification de la cession à la Société ou sur acceptation de la cession par la Société.
Chapitre III. - Assemblées générales d’actionnaires
Art. 8. Pouvoirs de l’assemblée générale des actionnaires. Les actionnaires exercent leurs droits collectifs en assemblée
générale d’actionnaires. Toute assemblée générale d’actionnaires de la Société régulièrement constituée représente l’en-
semble des actionnaires de la Société. L’assemblée générale des actionnaires est investie des pouvoirs qui lui sont
expressément réservés par la Loi et par les présents statuts.
Si la Société a un actionnaire unique, toute référence faite à «l’assemblée générale des actionnaires» devra, selon le
contexte et le cas échéant, être entendue comme une référence à «l’actionnaire unique», et les pouvoirs conférés à
l’assemblée générale des actionnaires devront être exercés par l’actionnaire unique.
Art. 9. Convocation des assemblées générales d’actionnaires. L'assemblée générale des actionnaires de la Société peut,
à tout moment, être convoquée par le conseil d'administration ou, le cas échéant, par le(s) commissaire(s) aux comptes.
L'assemblée générale des actionnaires doit obligatoirement être convoquée par le conseil d'administration ou par le
(s) commissaire(s) aux comptes sur demande écrite d’un ou plusieurs actionnaires représentant au moins dix pour cent
(10%) du capital social de la Société. En pareil cas, l’assemblée générale des actionnaires devra être tenue dans un délai
d'un (1) mois à compter de la réception de cette demande.
89694
L
U X E M B O U R G
Les convocations pour toute assemblée générale des actionnaires contiennent la date, l’heure, le lieu et l’ordre du jour
de l’assemblée et sont adressées aux actionnaires à l’adresse qui figurent dans le registre d’actions, à un intervalle minimum
de huit (8) jours, et au moins huit (8) jours avant la date prévue pour l’assemblée générale des actionnaires.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et ont renoncé à toute formalité de convocation, l’assemblée
générale des actionnaires peut être tenue sans convocation préalable, ni publication.
Art. 10. Conduite des assemblées générales d’actionnaires. L'assemblée générale annuelle des actionnaires doit être
tenue à Luxembourg, au siège social de la Société ou à tout autre endroit au Luxembourg tel qu’indiqué dans la convo-
cation, le 5 Mai à 10 heure(s). Si la date indiquée est un jour férié, l’assemblée générale des actionnaires aura lieu le jour
ouvrable suivant. Les autres assemblées générales d’actionnaires pourront se tenir à l’endroit et l’heure indiqués dans les
convocations respectives.
Un bureau de l’assemblée doit être constitué à chaque assemblée générale d’actionnaires, composé d'un président,
d'un secrétaire et d'un scrutateur, sans qu'il ne soit nécessaire que ces membres du bureau de l’assemblée soient ac-
tionnaires ou membres du conseil d'administration. Si tous les actionnaires présents à l’assemblée générale décident qu’ils
sont en mesure de contrôler la régularité des votes, les actionnaires peuvent, à l’unanimité, décider de nommer unique-
ment (i) un président et un secrétaire ou (ii) une seule personne chargée d’assurer les fonctions du bureau de l’assemblée,
rendant ainsi inutile la nomination d’un scrutateur. Toute référence faite au «bureau de l’assemblée» devra en ce cas être
entendue comme faisant référence aux «président et secrétaire» ou, le cas échéant et selon le contexte, à «la personne
unique qui assume le rôle de bureau de l’assemblée». Le bureau doit notamment s’assurer que l’assemblée est tenue en
conformité avec les règles applicables et, en particulier, en conformité avec les règles relatives à la convocation, aux
conditions de majorité, au partage des voix et à la représentation des actionnaires.
Une liste de présence doit être tenue à toute assemblée générale d’actionnaires.
Un actionnaire peut participer à toute assemblée générale des actionnaires en désignant une autre personne comme
son mandataire par écrit ou par télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Une per-
sonne peut représenter plusieurs ou même tous les actionnaires.
Les actionnaires qui prennent part a une assemblée par conférence téléphonique, vidéoconférence ou par tout autre
moyen de communication permettant leur identification et permettant à toutes les personnes participant à l’assemblée
de s'entendre mutuellement sans discontinuité, garantissant une participation effective à l’assemblée, sont réputés être
présents pour le calcul du quorum et des voix, à condition que de tels moyens de communication soient disponibles sur
les lieux de l’assemblée.
Chaque actionnaire peut voter à une assemblée générale des actionnaires au moyen d'un bulletin de vote signé, envoyé
par courrier, courrier électronique, télécopie ou tout autre moyen de communication au siège social de la Société ou à
l’adresse indiquée dans la convocation. Les actionnaires ne peuvent utiliser que les bulletins de vote fournis par la Société
qui indiquent au moins le lieu, la date et l’heure de l’assemblée, l’ordre du jour de l’assemblée, les résolutions soumises
à l’assemblée, ainsi que pour chaque résolution, trois cases à cocher permettant à l’actionnaire de voter en faveur ou
contre la résolution proposée, ou d'exprimer une abstention par rapport à chacune des résolutions proposées, en cochant
la case appropriée.
Les bulletins de vote qui, pour une résolution proposée, n'indiquent pas uniquement (i) un vote en faveur ou (ii) contre
résolution proposée ou (iii) exprimant une abstention sont nuls au regard de cette résolution. La Société ne tiendra
compte que des bulletins de vote reçus avant la tenue de l’assemblée générale des actionnaires à laquelle ils se rapportent.
Art. 11. Quorum et vote. Chaque action donne droit à une voix en assemblée générale d’actionnaires.
Sauf disposition contraire de la Loi ou des statuts, les décisions prises en assemblée générale d’actionnaires dûment
convoquées ne requièrent aucune condition de quorum et sont adoptées à la majorité simple des voix valablement
exprimées quelle que soit la part du capital social représentée. Les abstentions et les votes blancs ou nuls ne sont pas
pris en compte.
Art. 12. Modification des statuts. Sauf disposition contraire, les présents statuts peuvent être modifiés à la majorité
des deux-tiers des voix des actionnaires valablement exprimées lors d’une assemblée générale des actionnaires à laquelle
plus de la moitié du capital social de la Société est présente ou représentée. Si le quorum n’est pas atteint à une assemblée,
une seconde assemblée pourra être convoquée dans les conditions prévues par la Loi et les présents statuts qui pourra
alors délibérer quel que soit le quorum et au cours de laquelle les décisions seront adoptées à la majorité des deux-tiers
des voix valablement exprimées. Les abstentions et les votes blancs ou nuls ne sont pas pris en compte.
Art. 13. Changement de nationalité. Les actionnaires ne peuvent changer la nationalité de la Société qu’avec le con-
sentement unanime des actionnaires.
Art. 14. Ajournement des assemblées générales des actionnaires. Dans les conditions prévues par la Loi, le conseil
d’administration peut, ajourner séance tenante, une assemblée générale d’actionnaires à quatre (4) semaines. Le conseil
d’administration peut prendre une telle décision à la demande des actionnaires représentant au moins vingt pour cent
(20%) du capital social de la Société. Dans l’hypothèse d’un ajournement, toute décision déjà adoptée par l’assemblée
générale des actionnaires sera annulée.
89695
L
U X E M B O U R G
Art. 15. Procès-verbal des assemblées générales d’actionnaires. Le bureau de toute assemblée générale des actionnaires
doit dresser un procès-verbal de l’assemblée qui doit être signé par les membres du bureau de l’assemblée ainsi que par
tout autre actionnaire à sa demande.
Toute copie ou extrait de ces procès-verbaux originaux, à produire dans le cadre de procédures judiciaires ou à
remettre à tout tiers devra être certifié(e) conforme à l’original par le notaire dépositaire de l’acte original dans l’hypothèse
où l’assemblée aurait été retranscrite dans un acte authentique, ou devra être signé par le président du conseil d’admi-
nistration ou par deux membres du conseil d’administration.
Chapitre IV. - Administration
Art. 16. Composition et pouvoirs du conseil d’administration. La Société est gérée par un conseil d’administration
composé d’au moins trois (3) membres. Cependant, lorsque la Société a été constituée par un actionnaire unique ou
lorsqu’il apparaît, lors d’une assemblée générale d’actionnaires, que toutes les actions émises par une Société sont déte-
nues par un actionnaire unique, la Société peut être gérée par un administrateur unique jusqu’à la prochaine assemblée
générale d’actionnaires consécutive à l’augmentation du nombre d’actionnaires. Dans cette hypothèse, le cas échéant et
lorsque l’expression «administrateur unique» n’est pas mentionnée expressément dans les présents statuts, une référence
au «conseil d’administration» utilisée dans les présents statuts doit être entendue comme une référence à l’«administra-
teur unique».
Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société et pour prendre
toute mesure nécessaire ou utile afin de réaliser l’objet social de la Société, à l’exception des pouvoirs réservés par la Loi
ou par les présents statuts à l’assemblée générale des actionnaires.
Art. 17. Gestion journalière. La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en rapport
avec une telle gestion journalière peut, en conformité avec l’article 60 de la Loi être déléguée à un ou plusieurs adminis-
trateurs, dirigeants ou mandataires, agissant individuellement ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs
pouvoirs seront déterminés par une décision du conseil d’administration.
La Société peut également conférer des pouvoirs spéciaux au moyen d’une procuration authentique ou d’un acte sous
seing privé.
Art. 18. Nomination, révocation et durée des mandats des administrateurs. Les administrateurs sont nommés par
l’assemblée générale des actionnaires qui détermine leur rémunération et la durée de leur mandat.
La durée du mandat d’un administrateur ne peut excéder six (6) ans et chaque administrateur doit rester en fonction
jusqu’à ce qu’un successeur ait été désigné. Les administrateurs peuvent faire l’objet de réélections successives.
Chaque administrateur est nommé à la majorité simple des voix valablement exprimées à une assemblée générale des
actionnaires.
Chaque administrateur peut être révoqué de ses fonctions à tout moment et sans motif par l’assemblée générale des
actionnaires à la majorité simple voix valablement exprimées.
Si une personne morale est nommée en tant qu’administrateur de la Société, cette personne morale doit désigner une
personne physique en qualité de représentant permanent qui doit assurer cette fonction au nom et pour le compte de
la personne morale. La personne morale peut révoquer son représentant permanent uniquement si elle nomme simul-
tanément son successeur. Une personne physique peut uniquement être le représentant permanent d’un seul (1)
administrateur de la Société et ne peut être simultanément administrateur de la Société.
Art. 19. Vacance d’un poste d’administrateur. Dans l’hypothèse où un poste d’administrateur deviendrait vacant suite
au décès, à l’incapacité juridique, à la faillite, à la retraite ou autre, cette vacance pourra être comblée à titre temporaire
et pour une durée ne pouvant excéder le mandat initial de l’administrateur qui fait l’objet d’un remplacement par les
administrateurs restants jusqu’à ce que la prochaine assemblée générale d’actionnaires, appelée à statuer sur la nomination
permanente d’un nouvel administrateur en conformité avec les dispositions légales applicables.
Dans l’hypothèse où la vacance surviendrait alors que la Société est gérée que par un administrateur unique, cette
vacance devra être comblée sans délai par l’assemblée générale des actionnaires.
Art. 20. Convocation aux conseils d’administration. Le conseil d’administration se réunit à la demande du président,
ou de n’importe quel administrateur. Les réunions du conseil d’administration doivent être tenues au siège social de la
Société sauf indication contraire dans la convocation.
Une convocation écrite à toute réunion du conseil d’administration doit être adressée aux administrateurs vingt-quatre
(24) heures au moins avant l’heure prévue pour la réunion, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature et les motifs de
cette urgence devront être exposés dans la convocation. Cette convocation peut être omise si chaque administrateur y
consent par écrit, par télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, une copie dudit document
signé constituant une preuve suffisante d’un tel accord. Aucune convocation préalable ne sera exigée pour toute réunion
du conseil d’administration dont l’heure et l’endroit auront été déterminés dans une décision précédente adoptée par le
conseil d’administration et qui aura été communiquée à l’ensemble des membres du conseil d’administration.
Aucune convocation préalable n’est requise dans l’hypothèse où tous les membres du conseil d’administration sont
présents ou représentés à une réunion du conseil d’administration et renonceraient à toute formalité de convocation ou
89696
L
U X E M B O U R G
dans l’hypothèse où des décisions écrites auraient été approuvées et signées par tous les membres du conseil d’admi-
nistration.
Art. 21. Conduite des réunions du conseil d’administration. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un
président. Il peut également élire un secrétaire qui n’est pas nécessairement un administrateur et qui est chargé de la
tenue du procès-verbal de chaque conseil d’administration.
Le président doit présider toute réunion du conseil d’administration, mais, en son absence, le conseil d’administration
peut nommer un autre administrateur en qualité de président temporaire par une décision adoptée à la majorité des
administrateurs présents.
Tout administrateur peut participer à toute réunion du conseil d’administration en désignant comme mandataire un
autre membre du conseil d’administration par écrit, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen analogue de
communication, la copie d’une telle désignation constituant une preuve suffisante d’un tel mandat.
Les réunions du conseil d’administration peuvent aussi être tenues par conférence téléphonique, vidéoconférence ou
par tout autre moyen de communication autorisant les personnes participant à de telles réunions de s’entendre les unes
les autres de manière continue et permettant une participation effective à ces réunions. La participation à une réunion
par ces moyens équivaudra à une participation en personne et la réunion devra être considérée comme ayant été tenue
au siège social de la Société.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer ou statuer que si la moitié au moins des administrateurs est
présente ou représentée.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés. En cas de partage des
voix, le président a une voix prépondérante.
Sauf disposition contraire de la Loi, tout administrateur qui a, directement ou indirectement, un intérêt dans une
opération soumise à l’autorisation du conseil d’administration qui serait contraire aux intérêts de la Société, doit informer
le conseil d’administration de ce conflit d’intérêts et cette déclaration doit être actée dans le procès-verbal du conseil
d’administration. L’administrateur concerné ne peut prendre part ni aux discussions relatives à cette opération, ni au vote
y afférent. Ce conflit d’intérêts doit également faire l’objet d’une communication aux actionnaires, lors de la prochaine
assemblée générale des actionnaires, et avant toute prise de décision de l’assemblée générale des actionnaires sur tout
autre point à l’ordre du jour.
Lorsque la Société ne comprend qu’un administrateur unique, les opérations conclues entre la Société et cet admi-
nistrateur en situation de conflit d’intérêts avec la Société doivent simplement être mentionnées dans la décision de
l’administrateur unique.
Les règles du conflit d’intérêts ne s’appliquent pas lorsque la décision du conseil d’administration ou de l’administrateur
unique se rapporte à des opérations courantes, conclues à des conditions normales.
Le conseil d’administration peut, à l’unanimité, adopter des décisions par voie circulaire en exprimant son consente-
ment par écrit, par télécopie, par courrier électronique ou par tout autre moyen analogue de communication. Les
administrateurs peuvent exprimer leur consentement séparément, l’intégralité des consentements constituant une preuve
de l’adoption des décisions. La date d’adoption de ces décisions sera la date de la dernière signature.
Art. 22. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration - procès-verbaux des décisions de l’administrateur
unique. Le procès-verbal de toute réunion du conseil d’administration doit être signé par le président du conseil d’ad-
ministration, ou en son absence, par le président temporaire, ou par deux (2) administrateurs présents. Des copies ou
extraits de ces procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou d’une autre manière devront être signés par le
président du conseil d’administration ou par deux (2) administrateurs.
Les décisions de l’administrateur unique doivent être retranscrites dans des procès-verbaux qui doivent être signés
par l’administrateur unique. Des copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou d’une
autre manière devront être signés par l’administrateur unique.
Art. 23. Relations avec les tiers. La Société est engagée à l’égard des tiers en toutes circonstances par (i) la signature
de l’administrateur unique ou, si la société a plusieurs administrateurs, par la signature conjointe de deux (2) administra-
teurs ou par (ii) la signature unique ou les signatures conjointes de toute(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) un tel
pouvoir aura été délégué par le conseil d’administration dans les limites d’une telle délégation.
Dans les limites de la gestion journalière, la Société est engagée à l’égard des tiers par la signature de toute(s) personne
(s) à laquelle (auxquelles) un tel pouvoir aura été délégué par le conseil d’administration, agissant individuellement ou
conjointement dans les limites d’une telle délégation.
Chapitre V. - Audit et surveillance de la société
Art. 24. Commissaire aux comptes. Les opérations de la Société feront l’objet d’une surveillance par un ou plusieurs
commissaires aux comptes. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera
la durée de leurs fonctions, qui ne pourra excéder six (6) ans.
Tout commissaire aux comptes peut être révoqué à tout moment, sans préavis et sans motif, par l’assemblée générale
des actionnaires.
89697
L
U X E M B O U R G
Les commissaires aux comptes ont un droit illimité de surveillance et de contrôle permanents sur toutes les opérations
de la Société.
Si l’assemblée générale des actionnaires de la Société désigne un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés confor-
mément à l’article 69 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la
comptabilité et les comptes annuels des entreprises, telle que modifiée, l’obligation de nommer un (des) commissaire(s)
aux comptes est supprimée.
Le réviseur d'entreprises agréé peut être révoqué par l’assemblée générale des actionnaires uniquement pour juste
motif ou avec son accord.
Chapitre VI. - Exercice social - Affectation des bénéfices - Acomptes sur dividendes
Art. 25. Exercice social. L’exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine
le trente et un décembre de la même année.
Art. 26. Comptes annuels - Affectation des bénéfices. Au terme de chaque exercice social, les comptes sont clôturés
et le conseil d'administration dresse un inventaire de l’actif et du passif de la Société, le bilan et le compte de profits et
pertes conformément à la Loi.
Sur les bénéfices annuels nets de la Société, cinq pour cent (5 %) au moins seront affectés à la réserve légale. Cette
affectation cessera d'être obligatoire dès que et tant que le montant total de la réserve légale de la Société atteindra dix
pour cent (10%) du capital social de la Société.
Les sommes apportées à une réserve de la Société par un actionnaire peuvent également être affectées à la réserve
légale, si l’actionnaire apporteur y consent.
En cas de réduction du capital social, la réserve légale de la Société pourra être réduite en proportion afin qu'elle
n'excède pas dix pour cent (10%) du capital social.
Sur proposition du conseil d’administration, l’assemblée générale des actionnaires décide de l’affectation du solde des
bénéfices distribuables de la Société conformément à la Loi et aux présents statuts.
Art. 27. Acomptes sur dividendes - Prime d'émission et primes assimilées. Le conseil d’administration peut décider de
distribuer des acomptes sur dividendes dans le respect des conditions prévues par la Loi.
Toute prime d'émission, prime assimilée ou autre réserve distribuable peut être librement distribuée aux actionnaires
sous réserve des dispositions de la Loi et des présents statuts.
Chapitre VII. - Liquidation
Art. 28. Liquidation. En cas de dissolution de la Société, conformément à l’article 3.2 des présents statuts, la liquidation
sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l’assemblée générale des actionnaires ayant décidé la disso-
lution de la Société et qui fixera les pouvoirs et émoluments de chacun des liquidateurs. Sauf disposition contraire, les
liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et du passif de la Société.
Chapitre VIII. - Disposition finale - Loi applicable
Art. 29. Loi applicable. Tout ce qui n’est pas régi par les présents statuts sera déterminé en conformité avec la Loi.
<i>Dispositions transitoiresi>
1. Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre
2014.
2. La première assemblée générale des actionnaires sera tenue en 2014.
3. Des acomptes sur dividendes pourront être distribués au cours du premier exercice social de la Société.
<i>Souscription et paiementi>
Les cinquante mille (50.000) actions émises ont été souscrites par VCK Lease Stichting, susmentionnée, pour un prix
de cinquante mille dollars américains (USD 50.000).
Toutes les actions souscrites par VCK Lease Stichting, susmentionnée, ont été intégralement libérées par voie d’apport
en numéraire de sorte que le montant de cinquante mille dollars américains (USD 50.000) est dès à présent à la disposition
de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions prévues par ou posées par l’article 26 de la Loi et
déclare expressément qu’elles ont été remplies.
<i>Fraisi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution est évalué à environ mille cinq cents Euros (EUR 1.500,-).
89698
L
U X E M B O U R G
<i>Décisions de l’actionnaire uniquei>
L’actionnaire unique constituant, représentant l’intégralité du capital social de la Société et ayant renoncé aux formalités
de convocation, a adopté les décisions suivantes:
1. L'adresse du siège social de la Société est établie au 5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, Grand-Duché
de Luxembourg.
2. Mr. Claude Crauser, né le 22 avril 1981 à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg résidant professionnellement
au 5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg est nommé seul administrateur jusqu’à
l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes annuels du premier exercice social de la Société.
3. Grant Thornton Lux Audit S.A., société anonyme, constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxem-
bourg, ayant son siège social au 83 Pafebruch, L-8308 Capellen et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés
sous le numéro B43.298, est nommé en tant que réviseur d’entreprises agréés pour une période se terminant à l’assemblée
générale des actionnaires appelée à approuver les comptes de l’exercice social se terminant le 31 décembre 2018.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate, sur demande de la partie comparante, que le présent
acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction en français; à la demande de la même partie comparante et en
cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
L'acte ayant été lu au mandataire de la partie comparante connu du notaire instrumentant par nom, prénom, et
résidence, ledit mandataire de la partie comparante a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 juin 2014. Relation: LAC/2014/29714. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 3 juillet 2014.
Référence de publication: 2014094363/667.
(140112850) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2014.
OAK International S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 139.118.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014067712/9.
(140079062) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2014.
Swiss Life Funds (Lux), Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1616 Luxembourg, 28-32, place de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 69.186.
The board of directors (the "Board of Directors") of Swiss Life Funds (LUX) (the "Sicav") has decided to merge Swiss
Life Funds (LUX) Equity Global Diversified (the "Absorbed Sub-Fund") into Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High
Dividend (the "Absorbing Sub-Fund" and together the "Sub-Funds"). The merger shall become effective on 25 August
2014 (the "Effective Date").
This notice describes the implications of the contemplated merger. Please contact your financial ad-
visor if you have any questions on the content of this notice. The merger may impact your tax situation.
Shareholders should contact their tax advisor for specific tax advice in relation to the merger.
Capitalized terms not defined herein have the same meaning as in the prospectus of the Sicav.
Key aspects and timing
- The merger shall become effective and final between the Absorbed Sub-Fund and the Absorbing Sub-Fund and vis-
à-vis third parties on the Effective Date.
- On the Effective Date, all assets and liabilities of the Absorbed Sub-Fund will be transferred to the Absorbing Sub-
Fund. The Absorbed Sub-Fund will then cease to exist.
- A comparison of the key features of the Absorbed Sub-Fund and the Absorbing Sub-Fund is available under section
"Impact of the merger on shareholders of the Absorbed Sub-Fund" below.
- No general meeting of shareholders shall be convened in order to approve the merger.
89699
L
U X E M B O U R G
Shareholders holding shares of the Absorbed Sub-Fund on the Effective Date will automatically be issued shares of the
Absorbing Sub-Fund in exchange for their shares of the Absorbed Sub-Fund, in accordance with the relevant share
exchange ratio.
Shareholders of the Absorbed Sub-Fund or the Absorbing Sub-Fund who do not agree with the merger have the right
to request, prior to 18 August 2014 redemption or conversion of their shares into shares of that same or a different class
of another sub-fund of the Sicav, without redemption or conversion charges. Please see the section "Rights of shareholders
in relation to the merger" below.
- Subscriptions, redemptions and/or conversions of shares of the Absorbed Sub-Fund will be suspended as indicated
under section "Procedural aspects" below.
- Other procedural aspects of the merger are set out in section "Procedural aspects" below.
- The merger has been approved by the Commission de Surveillance du Secteur Financier (the "CSSF").
- The timetable below summarises the key steps of the merger.
Notice sent to shareholders
18 July 2014
End of current accounting period of the Absorbed Sub-Fund
18 August 2014
Calculation of share exchange ratio
25 August 2014
Effective Date
25 August 2014
Background to and rationale for the merger
The Board considers that as a result of the Swiss Life's decision to streamline the fund range by merging comparable
investment funds, it would be in the best interest of the shareholders of the Sub-Funds that their portfolios were managed
in common in order to reduce costs, and thus to secure the ability to invest efficiently.
Furthermore, the Board of Directors considers that a merger is in the best interest of shareholders of the Sub-Funds,
as (i) the Absorbed Sub-Fund has an investment objective and policy compatible with that of the Absorbing Sub-Fund, (ii)
the typical investor profile of the Absorbing Sub-Fund is compatible with that of the Absorbed Sub-Fund, and (iii) the
assets under management of the Absorbing Sub-Fund will increase as a result of the merger and therefore the merger
will reduce over-all fund expenses and provide better efficient asset management to shareholders.
Impact of the merger on shareholders of the Absorbed Sub-Fund
This section compares the key features of the Absorbed Sub-Fund to that of the Absorbing Sub-Fund and highlights
material differences. The main characteristics of the Absorbing Sub-Fund, as described in the prospectus of the Sicav and
in the key investor information document ("KIID"), will remain the same after the Effective Date. Shareholders of the
Absorbed Sub-Fund should carefully read the description of the Absorbing Sub-Fund in the prospectus of the Sicav and
in the KIID of the Sub-Fund before making any decision in relation to the merger.
Key features of the Sub-Funds
Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Diversi-
fied
(absorbed)
Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Di-
vidend
(absorbing)
Legal Regime
UCITS
UCITS
Investment Ob-
jective
The objective of the Sub-Fund is to achieve long-
term capital gain by investing and/or being exposed
in a globally diversified portfolio of equities
through direct or indirect investments via other
UCITS and/or UCIs.
The objective of the Sub-Fund is to achieve a high
long term capital growth by and/or being exposed
in a globally diversified portfolio of companies with
above-average yearly dividend payments through
direct or indirect investments via other UCITS
and/or UCIs.
Investment Poli-
cy
The Sub-Fund invests:
* at least two thirds of its assets in shares from
around the world;
* up to one third of its assets in other tradable
securities and money market instruments.
Investments can be made in various currencies.
To achieve its aim, the Sub-Fund may use financial
instruments whose prices depend on the perfor-
mance of other financial instruments (derivatives).
The Sub-Fund invests:
* at least two thirds of its total assets in shares
issued by companies around the world that make
above-average annual dividend payments;
* up to one third of its total assets in other tradable
securities and money market instruments.
The Sub-Fund will invest not more than 10% if its
net assets in units of UCITS and/or UCIs.
Investments can be made in various currencies.
To achieve its aim, the sub-fund may invest up to
10% of its assets in financial instruments whose
prices depend on the performance of other finan-
cial instruments (derivatives).
Classes of sha-
res impacted by
the merger
Class I - Capitalisation
Class R - Capitalisation
Class I - Capitalisation
Class R - Capitalisation
89700
L
U X E M B O U R G
Risk reward
profile (SRRI)
Class I - Capitalisation: 6
Class R - Capitalisation: 5
Class I - Capitalisation: 6
Class R - Capitalisation: 5
Subscription Fee 5 %
identical
Redemption Fee None
identical
Conversion Fee Up to 0.5%
identical
Performance
fees
None
None
Ongoing charge
from the Sub-
Fund over a year
Up to 2.51% (depending on the class of shares)
Up to 1.82% (depending on the class of shares)
Other fees:
- Maximum an-
nual manage-
ment fees (incl.
distribution
fees)
Class I - Capitalisation: 1.50 % of the NAV
Class R - Capitalisation: 1.50% of the NAV
Identical
Identical
- Maximum an-
nual custodian
fees
Class I - Capitalisation: 0.07% of the NAV
Class R - Capitalisation: 0.07% of the NAV
Identical
Identical
- Maximum an-
nual administra-
tion fees
Class I - Capitalisation: 0.56% of the NAV
Class R - Capitalisation: 0.56% of the NAV
Identical
Identical
- Maximum an-
nual registrar
and transfer fees
Class I - Capitalisation: 0.03% of the NAV
Class R - Capitalisation: 0.03% of the NAV
Identical
Identical
NAV calculation Daily
Daily
Reference Cur-
rency
EUR
EUR
Investment Ma-
nager
Swiss Life Asset Management (France)
Identical
No rebalancing of the Absorbed Sub-Fund's portfolio will be carried out prior the Merger.
<i>Profile of typical investor
i>The Absorbed Sub-Funds is suitable for the investor who can set aside the invested capital for at least five years. The
Absorbing Sub-Fund is aimed at investors who wish to withdraw their money over a five-year-time period, or ideally ten-
year-time period and are prepared to take the higher risks associated with equity investments for the aim of realising high
returns and who are thus able to accept temporary losses. The Absorbed and the Absorbing Sub-Funds do not differ
with regard to the profile of the typical investor.
<i>Distribution policy
i>The distribution policy is the same for the Absorbed Sub-Fund and the Absorbing Sub-Fund.
<i>Fees and expenses
i>Fees, costs or any other charges applicable in the Absorbing Sub-Fund will not change after the merger.
<i>Minimum investment and subsequent investment, and holding requirements
i>The minimum amount of investment and subsequent investment as well as the minimum holding requirements for the
above share classes of the Absorbing Sub-Fund are the same as those applicable to the corresponding share classes of
the Absorbed Sub-Fund.
Criteria for valuation of assets and liabilities
For the purpose of calculating the relevant exchange ratios, the rules laid down in the Articles of Incorporation and
the prospectus of the Sicav for the calculation of the NAV will apply to determine the value of the assets and liabilities
of the Absorbed Sub-Fund and the Absorbing Sub-Fund.
Impact of the merger on shareholders of the Absorbing Sub-Fund
The merger is not expected to impact the Absorbing Sub-Fund's shareholders.
Subscriptions for or conversions to and redemptions of shares of the Absorbing Sub-Fund will not be suspended during
the merger process.
89701
L
U X E M B O U R G
Rights of shareholders in relation to the merger
Shareholders of the Absorbed Sub-Fund holding shares in the Absorbed Sub-Fund on the Effective Date will automa-
tically be issued, in exchange for their shares in the Absorbed Sub-Fund, a number of shares of the corresponding share
classes of the Absorbing Sub-Fund equivalent to the number of shares held in relevant class of the Absorbed Sub-Fund
multiplied by the relevant share exchange ratio which shall be calculated for each class of shares on the basis of its
respective NAV as of 25 August 2014. In case the application of the relevant exchange ratios does not lead to the issuance
of full shares, the shareholders of the Absorbed Sub-Fund will receive fractions of shares to one thousandth share within
the Absorbing Sub-Fund.
No subscription fee will be levied within the Absorbing Sub-Fund as a result of the merger.
Shareholders of the Absorbed Sub-Fund will acquire rights as shareholders of the Absorbing Sub-Fund from the Ef-
fective Date.
Shareholders of the Absorbed Sub-Fund and of the Absorbing Sub-Fund not agreeing with the merger will be given
the possibility to request the redemption or the conversion of their shares of the Absorbed Sub-Fund and/or the Ab-
sorbing Sub-Fund into shares of that same or a different class of another sub-fund of the Sicav at the applicable NAV of
the relevant shares, without any redemption or conversion charges (other than charges retained by the Sicav to meet
disinvestment costs) during at least 30 calendar days following the date of sending out of the notice to shareholders.
Impact of the merger on the portfolio of the Absorbing Sub-Fund
The merger is not expected to impact the Absorbing Sub-Fund's portfolio.
Procedural aspects
<i>No shareholder vote required
i>No shareholder vote is required in order to carry out the merger under article 24 of the Articles of Incorporation of
the Sicav. Shareholders of the Absorbed Sub-Fund and of the Absorbing Sub-Fund not agreeing with the merger may
request the redemption or the conversion of their shares as stated under section "Rights of shareholders in relation to
the merger" prior to 18 August 2014.
<i>Suspensions in dealings
i>In order to implement the procedures needed for the merger in an orderly and timely manner, the Board of Directors
has decided that:
* Subscriptions for or conversions to and redemption of shares of the Absorbed Sub-Fund will no longer be accepted
or processed from 18 August 2014; and
* Subscriptions for or conversions to and redemptions of shares of the Absorbing Sub-Fund will not be suspended
during the merger process.
<i>Confirmation of merger
i>Each shareholder in the Absorbed Sub-Fund will receive a notification confirming (i) that the merger has been carried
out and (ii) the number of shares of the corresponding class of shares of the Absorbing Sub-Fund that they hold after the
merger.
<i>Publications
i>The merger and its Effective Date shall be announced in the Luxembourg official journal (Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations) before the Effective Date. This information shall also be made publicly available, when regulatory
mandatory, in other jurisdictions where shares of the Absorbed Sub-Fund and the Absorbing Sub-Fund are distributed.
<i>Approval by competent authorities
i>The merger has been approved by the CSSF which is the competent authority supervising the Sicav in Luxembourg.
Costs of the merger
The management company of the Sicav will bear the legal, advisory and administrative costs and expenses associated
with the preparation and completion of the merger.
Taxation
The merger of the Absorbed Sub-Fund into the Absorbing Sub-Fund may have tax consequences for shareholders.
Shareholders should consult their professional advisers about the consequences of this merger on their individual tax
position.
Additional information
<i>Merger reports
i>PricewaterhouseCoopers Société coopérative, Luxembourg, the authorised auditor of the Sicav in respect of the
merger, will prepare reports on the merger which shall include a validation of the following items:
1) the criteria adopted for valuation of the assets and/or liabilities for the purposes of calculating the exchange ratios;
89702
L
U X E M B O U R G
2) the calculation method for determining the exchange ratios; and
3) the final exchange ratios.
The merger report regarding items 1) and 2) above shall be made available at the registered office of the Sicav on
request and free of charge to the shareholders of the Absorbed Sub-Fund and of the Absorbing Sub-Fund and the CSSF
from the Effective Date.
<i>Additional documents available
i>The following documents are available at the registered office of the Sicav on request and free of charge to the
shareholders of the Absorbed Sub-Fund and of the Absorbing Sub-Fund:
- the merger project drawn-up by the Board of Directors containing detailed information on the merger, including the
calculation method of the share exchange ratios (the "Merger Project");
- a statement by the custodian bank of the Sicav confirming that they have verified compliance of the Merger Project
with the terms of the law of 17 December 2010 on undertakings for collective investment and the articles of incorporation
of the Sicav;
- the prospectus of the Sicav; and
- the key investor information documents of the Absorbed Sub-Fund and the Absorbing Sub-Fund. The Board of
Directors draws the attention of the shareholders of the Absorbed Sub-Fund to the desirability of reading the KIID of
the Absorbing Sub-Fund before making any decision in relation to the merger.
Please contact your financial adviser or the registered office of the Sicav if you have questions regarding this matter.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2014097790/45/223.
Telpro Communications (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 113.242.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
«Par jugement du 24 avril 2014, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public en leurs
conclusions,
déclare closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société TELPRO COMMUNICATIONS (Lu-
xembourg) SA (B113242),
ordonne la publication du présent jugement par extrait au Mémorial;
dit que les frais sont à prélever sur l'actif réalisé, le solde étant à la charge du Trésor.»
Référence de publication: 2014068511/15.
(140079731) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2014.
Swiss Life Funds (Lux), Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1616 Luxembourg, 28-32, place de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 69.186.
The board of directors (the “Board of Directors”) of Swiss Life Funds (LUX) (the “Sicav”) has decided to merge Swiss
Life Funds (LUX) Portfolio Euro Zone Balanced (EUR) (the “Absorbed Sub-Fund”) into Swiss Life Funds (LUX) Portfolio
Global Balanced Harmony (EUR) (the “Absorbing Sub-Fund” and together the “Sub-Funds”). The merger shall become
effective on 25 August 2014 (the “Effective Date”).
This notice describes the implications of the contemplated merger. Please contact your financial advisor if you have
any questions on the content of this notice. The merger may impact your tax situation. Shareholders should contact their
tax advisor for specific tax advice in relation to the merger.
Capitalized terms not defined herein have the same meaning as in the prospectus of the Sicav.
Key aspects and timing
- The merger shall become effective and final between the Absorbed Sub-Fund and the Absorbing Sub-Fund and vis-
à-vis third parties on the Effective Date.
- On the Effective Date, all assets and liabilities of the Absorbed Sub-Fund will be transferred to the Absorbing Sub-
Fund. The Absorbed Sub-Fund will then cease to exist.
- A comparison of the key features of the Absorbed Sub-Fund and the Absorbing Sub-Fund is available under section
“Impact of the merger on shareholders of the Absorbed Sub-Fund” below.
- No general meeting of shareholders shall be convened in order to approve the merger.
89703
L
U X E M B O U R G
- Shareholders holding shares of the Absorbed Sub-Fund on the Effective Date will automatically be issued shares of
the Absorbing Sub-Fund in exchange for their shares of the Absorbed Sub-Fund, in accordance with the relevant share
exchange ratio.
- Shareholders of the Absorbed Sub-Fund or the Absorbing Sub-Fund who do not agree with the merger have the
right to request, prior to 18 August 2014 redemption or conversion of their shares into shares of that same or a different
class of another sub-fund of the Sicav, without redemption or conversion charges. Please see the section “Rights of
shareholders in relation to the merger” below.
- Subscriptions, redemptions and/or conversions of shares of the Absorbed Sub-Fund will be suspended as indicated
under section “Procedural aspects” below.
- Other procedural aspects of the merger are set out in section “Procedural aspects” below.
- The merger has been approved by the Commission de Surveillance du Secteur Financier (the “CSSF”).
- The timetable below summarises the key steps of the merger.
Notice sent to shareholders
18 July 2014
End of current accounting period of the Absorbed Sub-Fund
18 August 2014
Calculation of share exchange ratio
25 August 2014
Effective Date
25 August 2014
Background to and rationale for the merger
The Board considers that as a result of the Swiss Life's decision to streamline the fund range by merging comparable
investment funds, it would be in the best interest of the shareholders of the Sub-Funds that their portfolios were managed
in common in order to reduce costs, and thus to secure the ability to invest efficiently.
Furthermore, the Board of Directors considers that a merger is in the best interest of shareholders of the Sub-Funds,
as (i) the Absorbed Sub-Fund has an investment objective and policy compatible with that of the Absorbing Sub-Fund, (ii)
the typical investor profile of the Absorbing Sub-Fund is compatible with that of the Absorbed Sub-Fund, and (iii) the
assets under management of the Absorbing Sub-Fund will increase as a result of the merger and therefore the merger
will reduce over-all fund expenses and provide better efficient asset management to shareholders.
Impact of the merger on shareholders of the Absorbed Sub-Fund
This section compares the key features of the Absorbed Sub-Fund to that of the Absorbing Sub-Fund and highlights
material differences. The main characteristics of the Absorbing Sub-Fund, as described in the prospectus of the Sicav and
in the key investor information document (“KIID”), will remain the same after the Effective Date. Shareholders of the
Absorbed Sub-Fund should carefully read the description of the Absorbing Sub-Fund in the prospectus of the Sicav and
in the KIID of the Sub-Fund before making any decision in relation to the merger.
Key features of the Sub-Funds
Swiss Life Funds (LUX) Portfolio
Euro Zone Balanced (EUR)
(absorbed)
Swiss Life Funds (LUX) Portfolio
Global Balanced Harmony (EUR)
(absorbing)
Legal Regime
UCITS
UCITS
Investment
Objective
The objective of the Sub-Fund is to achieve mid to
long-term capital growth in Euro by investing and/
or being exposed directly or indirectly in shares
issued by major companies based in a member
country of the European Monetary Union and Eu-
ro-denominated bonds.
The objective of the Sub-Fund is to seek the best
combination of capital growth and interest income
from the Euro perspective by investing and/or be-
ing exposed in a broadly diversified portfolio of
global bonds and equities throuth direct or indirect
investments via other UCITS and/or UCIs.
Investment
Policy
The Sub-Fund invests:
* at least 30% of its assets in shares and other
equities issued by companies that have their regis-
tered office in the European Monetary Union;
* at least 40% of its assets in bonds or similar in-
terest-bearing financial instruments.
At least 80% of its assets must be invested in com-
panies that have their registered office in the Eu-
ropean Monetary Union or in interest-bearing
financial instruments denominated in euros. This
aim may also be achieved indirectly by buying funds.
To achieve its aim, the Sub-Fund may use financial
instruments whose prices depend on the perfor-
mance of other financial instruments (derivatives).
The Sub-Fund invests:
* at least 30% of its assets in shares or other equity
securities;
* at least 40% of its assets in bonds or similar in-
terest-bearing financial instruments. This aim may
also be achieved indirectly by buying funds.
To achieve its aim, the Sub-Fund may use financial
instruments whose prices depend on the perfor-
mance of other financial instruments (derivatives).
Class of shares
Class R - Capitalisation
Class R - Capitalisation
89704
L
U X E M B O U R G
Risk reward
profile (SRRI)
Class R - Capitalisation : 5
Class R - Capitalisation : 4
Subscription Fee 5 %
Identical
Redemption Fee None
Identical
Conversion Fee Up to 0.5 %
Identical
Performance
fees
None
Identical
Ongoing charge
from the Sub-
Fund over a year
1.73 %
1.93 %
Other fees :
- Maximum
annual manage-
ment fees
(incl. distribu-
tion fees)
Class R - Capitalisation : 1.25 % of the NAV
Identical
- Maximum
annual
custodian fees
Class R - Capitalisation : 0.07 % of the NAV
Identical
- Maximum
annual
administration
fees
Class R - Capitalisation : 0.56 % of the NAV
Identical
- Maximum
annual registrar
and transfer fees
Class R - Capitalisation : 0.03 % of the NAV
Identical
NAV calculation Daily
Daily
Reference
Currency
EUR
EUR
Investment Ma-
nager
Swiss Life Asset Management (France)
Identical
No rebalancing of the Absorbed Sub-Fund's portfolio will be carried out prior to the Merger.
<i>Profile of typical investor
i>The Absorbed Sub-Fund is suitable to the investor who can set aside the invested capital for at least three or five
years. The Absorbing Sub-Fund is aimed at investors who wish to withdraw their money over a five-year time period and
who is prepared to accept the risk linked to the investment in international equity and bonds markets. The Absorbed
and the Absorbing Sub-Funds do not differ with regard to the profile of the typical investor.
<i>Distribution policy
i>The distribution policy is the same for the Absorbed Sub-Fund and the Absorbing Sub-Fund.
<i>Fees and expenses
i>Fees, costs or any other charges applicable in the Absorbing Sub-Fund will not change after the merger.
<i>Minimum investment and subsequent investment, and holding requirements
i>The minimum amount of investment and subsequent investment as well as the minimum holding requirements for the
Absorbing Sub-Fund are the same as those applicable to the Absorbed Sub-Fund.
Criteria for valuation of assets and liabilities
For the purpose of calculating the exchange ratio, the rules laid down in the Articles of Incorporation and the pros-
pectus of the Sicav for the calculation of the NAV will apply to determine the value of the assets and liabilities of the
Absorbed Sub-Fund and the Absorbing Sub-Fund.
Impact of the merger on shareholders of the Absorbing Sub-Fund
The merger is not expected to impact the Absorbing Sub-Fund's shareholders.
Subscriptions for or conversions to and redemptions of shares of the Absorbing Sub-Fund will not be suspended during
the merger process.
Rights of shareholders in relation to the merger
Shareholders of the Absorbed Sub-Fund holding shares in the Absorbed Sub-Fund on the Effective Date will automa-
tically be issued, in exchange for their shares in the Absorbed Sub-Fund, a number of shares of the Absorbing Sub-Fund
89705
L
U X E M B O U R G
equivalent to the number of shares held in the Absorbed Sub-Fund multiplied by the exchange ratio which shall be
calculated on the basis of its NAV as of 28 August 2014. In case the application of the exchange ratio does not lead to
the issuance of full shares, the shareholders of the Absorbed Sub-Fund will receive fractions of shares to one thousandth
share within the Absorbing Sub-Fund.
No subscription fee will be levied within the Absorbing Sub-Fund as a result of the merger.
Shareholders of the Absorbed Sub-Fund will acquire rights as shareholders of the Absorbing Sub-Fund from the Ef-
fective Date.
Shareholders of the Absorbed Sub-Fund and of the Absorbing Sub-Fund not agreeing with the merger will be given
the possibility to request the redemption or the conversion of their shares of the Absorbed Sub-Fund and/or the Ab-
sorbing Sub-Fund into shares of that same or a different class of another sub-fund of the Sicav at the applicable NAV of
the relevant shares, without any redemption or conversion charges (other than charges retained by the Sicav to meet
disinvestment costs) during at least 30 calendar days following the date of sending out of the notice to shareholders.
Impact of the merger on the portfolio of the Absorbing Sub-Fund
The merger is not expected to impact the Absorbing Sub-Fund's portfolio.
Procedural aspects
<i>No shareholder vote required
i>No shareholder vote is required in order to carry out the merger under article 24 of the Articles of Incorporation of
the Sicav. Shareholders of the Absorbed Sub-Fund and of the Absorbing Sub-Fund not agreeing with the merger may
request the redemption or the conversion of their shares as stated under section “Rights of shareholders in relation to
the merger” prior to 18 August 2014.
<i>Suspensions in dealings
i>In order to implement the procedures needed for the merger in an orderly and timely manner, the Board of Directors
has decided that:
* Subscriptions for or conversions to and redemptions of shares of the Absorbed Sub-Fund will no longer be accepted
or processed from 18 August 2014; and
* Subscriptions for or conversions to and redemptions of shares of the Absorbing Sub-Fund will not be suspended
during the merger process.
<i>Confirmation of merger
i>Each shareholder in the Absorbed Sub-Fund will receive a notification confirming (i) that the merger has been carried
out and (ii) the number of shares of the Absorbing Sub-Fund that they hold after the merger.
<i>Publications
i>The merger and its Effective Date shall be announced in the Luxembourg official journal ( <i>Mémorial C, Recueil des Sociétési>
<i>et Associationsi> ) before the Effective Date. This information shall also be made publicly available, when regulatory manda-
tory, in other jurisdictions where shares of the Absorbed Sub-Fund and the Absorbing Sub-Fund are distributed.
<i>Approval by competent authorities
i>The merger has been approved by the CSSF which is the competent authority supervising the Sicav in Luxembourg.
Costs of the merger
The management company of the Sicav will bear the legal, advisory and administrative costs and expenses associated
with the preparation and completion of the merger.
Taxation
The merger of the Absorbed Sub-Fund into the Absorbing Sub-Fund may have tax consequences for shareholders.
Shareholders should consult their professional advisers about the consequences of this merger on their individual tax
position.
Additional information
<i>Merger reports
i>PricewaterhouseCoopers Société coopérative, Luxembourg, the authorised auditor of the Sicav in respect of the
merger, will prepare reports on the merger which shall include a validation of the following items:
1) the criteria adopted for valuation of the assets and/or liabilities for the purposes of calculating the exchange ratio;
2) the calculation method for determining the exchange ratio; and
3) the final exchange ratio.
The merger report regarding items 1) and 2) above shall be made available at the registered office of the Sicav on
request and free of charge to the shareholders of the Absorbed Sub-Fund and of the Absorbing Sub-Fund and the CSSF
from the Effective Date.
89706
L
U X E M B O U R G
<i>Additional documents available
i>The following documents are available at the registered office of the Sicav on request and free of charge to the
shareholders of the Absorbed Sub-Fund and of the Absorbing Sub-Fund:
- the merger project drawn-up by the Board of Directors containing detailed information on the merger, including the
calculation method of the share exchange ratio (the “Merger Project”);
- a statement by the custodian bank of the Sicav confirming that they have verified compliance of the Merger Project
with the terms of the law of 17 December 2010 on undertakings for collective investment and the articles of incorporation
of the Sicav;
- the prospectus of the Sicav; and
- the key investor information documents of the Absorbed Sub-Fund and the Absorbing Sub-Fund. The Board of
Directors draws the attention of the shareholders of the Absorbed Sub-Fund to the desirability of reading the KIID of
the Absorbing Sub-Fund before making any decision in relation to the merger.
Please contact your financial adviser or the registered office of the Sicav if you have questions regarding this matter.
<i>The Board of Directorsi>
.
Référence de publication: 2014097791/45/219.
Quirk Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 29.717.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 117.461.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions de l’associé unique prises en date du 15 mai 2014:
1. que la démission de M. Mario Cohn en tant que gérant de classe B est acceptée avec effet au 30 avril 2014;
2. que la démission de Mr. Giovanni La Forgia en tant que gérante de classe A est acceptée avec effet au 15 mai 2014;
3. que M. Carl Pivert avec adresse professionnelle au 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est nommée
nouveau gérant de classe A avec effet au 15 mai 2014 et ce pour une durée indéterminée;
4. que Mme. Virginia Strelen avec adresse professionnelle au 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est nommée
nouveau gérant de classe B avec effet au 30 avril 2014 et ce pour une durée indéterminée;
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 16 mai 2014.
Référence de publication: 2014069143/18.
(140081306) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2014.
Swiss Life Funds (Lux), Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1616 Luxembourg, 28-32, place de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 69.186.
The board of directors (the "Board of Directors") of Swiss Life Funds (LUX) (the "Sicav") has decided to merge Swiss
Life Funds (LUX) Equity Europe (the "Absorbed Sub-Fund") into Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone (the "Absorbing
Sub-Fund" and together the "Sub-Funds"). The merger shall become effective on 25 August 2014 (the "Effective Date").
This notice describes the implications of the contemplated merger. Please contact your financial advisor if you have
any questions on the content of this notice. The merger may impact your tax situation. Shareholders should contact their
tax advisor for specific tax advice in relation to the merger.
Capitalized terms not defined herein have the same meaning as in the prospectus of the Sicav.
Key aspects and timing
- The merger shall become effective and final between the Absorbed Sub-Fund and the Absorbing Sub-Fund and vis-
à-vis third parties on the Effective Date.
- On the Effective Date, all assets and liabilities of the Absorbed Sub-Fund will be transferred to the Absorbing Sub-
Fund. The Absorbed Sub-Fund will then cease to exist.
- A comparison of the key features of the Absorbed Sub-Fund and the Absorbing Sub-Fund is available under section
"Impact of the merger on shareholders of the Absorbed Sub-Fund" below.
- No general meeting of shareholders shall be convened in order to approve the merger.
- Shareholders holding shares of the Absorbed Sub-Fund on the Effective Date will automatically be issued shares of
the Absorbing Sub-Fund in exchange for their shares of the Absorbed Sub-Fund, in accordance with the relevant share
exchange ratio.
89707
L
U X E M B O U R G
- Shareholders of the Absorbed Sub-Fund or the Absorbing Sub-Fund who do not agree with the merger have the
right to request, prior to 18 August 2014 redemption or conversion of their shares into shares of that same or a different
class of another sub-fund of the Sicav, without redemption or conversion charges. Please see the section "Rights of
shareholders in relation to the merger" below.
- Subscriptions, redemptions and/or conversions of shares of the Absorbed Sub-Fund will be suspended as indicated
under section "Procedural aspects" below.
- Other procedural aspects of the merger are set out in section "Procedural aspects" below.
- The merger has been approved by the Commission de Surveillance du Secteur Financier (the "CSSF").
- The timetable below summarises the key steps of the merger.
Notice sent to shareholders
18 July 2014
End of current accounting period of the Absorbed Sub-Fund
18 August 2014
Calculation of share exchange ratio
25 August 2014
Effective Date
25 August 2014
Background to and rationale for the merger
The Board considers that as a result of the Swiss Life's decision to streamline the fund range by merging comparable
investment funds, it would be in the best interest of the shareholders of the Sub-Funds that their portfolios were managed
in common in order to reduce costs, and thus to secure the ability to invest efficiently.
Furthermore, the Board of Directors considers that a merger is in the best interest of shareholders of the Sub-Funds,
as (i) the Absorbed Sub-Fund has an investment objective and policy compatible with that of the Absorbing Sub-Fund, (ii)
the typical investor profile of the Absorbing Sub-Fund is compatible with that of the Absorbed Sub-Fund, and (iii) the
assets under management of the Absorbing Sub-Fund will increase as a result of the merger and therefore the merger
will reduce over-all fund expenses and provide better efficient asset management to shareholders.
Impact of the merger on shareholders of the Absorbed Sub-Fund
This section compares the key features of the Absorbed Sub-Fund to that of the Absorbing Sub-Fund and highlights
material differences. The main characteristics of the Absorbing Sub-Fund, as described in the prospectus of the Sicav and
in the key investor information document ("KIID"), will remain the same after the Effective Date. Shareholders of the
Absorbed Sub-Fund should carefully read the description of the Absorbing Sub-Fund in the prospectus of the Sicav and
in the KIID of the Sub-Fund before making any decision in relation to the merger.
<i>Key features of the Sub-Fundsi>
Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe
(absorbed)
Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone
(absorbing)
Legal Regime
UCITS
UCITS
Investment
Objective
The objective of the Sub-Fund is to achieve long-
term capital gain by investing and/or being exposed
in a diversified portfolio of equities of companies
that are incorporated in Europe.
The objective of the Sub-Fund is to achieve long-
term capital growth by investing and/or being ex-
posed in a diversified portfolio of equities of large
capitalized companies domiciled in a member state
of the European Monetary Union.
Investment
Policy
The Sub-Fund invests:
* at least two thirds of its total assets in European
shares;
* up to one third of its assets in other tradable
securities and money market instruments
To achieve its aim, the Sub-Fund may use financial
instruments whose prices depend on the perfor-
mance of other financial instruments (derivatives).
The Sub-Fund invests:
* at least two thirds of its total assets in shares
issued by companies with a high market capitalisa-
tion that have their registered office in a member
state of the European Monetary Union;
* up to one third of its total assets in other financial
instruments
The Sub-Fund will invest not more than 10% if its
net assets in units of UCITS and/or UCIs.
To achieve its aim, the Sub-Fund may use financial
instruments whose prices depend on the perfor-
mance of other financial instruments (derivatives).
Class of shares
Class I - Capitalisation
Class R - Capitalisation
Class R - Capitalisation
Risk reward
profile (SRRI)
Class I - Capitalisation : 6
Class R - Capitalisation : 6
Class R - Capitalisation : 7
Annual
registration tax
Class I - Capitalisation : 0.01% of the NAV
Class R - Capitalisation : 0.05% of the NAV
Class R - Capitalisation : 0.05% of the NAV
Subscription Fee 5 %
Identical
Redemption Fee None
Identical
89708
L
U X E M B O U R G
Conversion Fee Up to 0.50%
Identical
Performance
fees
None
Identical
Ongoing charge
from the Sub-
Fund over a year
Up to 2.13% (depending on the class of shares)
Up to 1.76% (depending on the class of shares)
Other fees :
- Maximum an-
nual manage-
ment fees (in-
cluding distribu-
tion fees)
Class I - Capitalisation : 1.50% of the NAV
Class R - Capitalisation : 1.50% of the NAV
Class R - Capitalisation : 1.50% of the NAV
- Maximum an-
nual custodian
fees
Class I - Capitalisation : 0.07% of the NAV
Class R - Capitalisation : 0.07% of the NAV
Class R - Capitalisation : 0.07% of the NAV
- Maximum an-
nual administra-
tion fees
Class I - Capitalisation : 0.56% of the NAV
Class R - Capitalisation : 0.56% of the NAV
Class R - Capitalisation : 0.56% of the NAV
- Maximum an-
nual registrar
and transfer fees
Class I - Capitalisation : 0.03% of the NAV
Class R - Capitalisation : 0.03% of the NAV
Class R - Capitalisation : 0.03% of the NAV
NAV calculation Daily
Daily
Reference
Currency
EUR
EUR
Investment
Manager
Swiss Life Asset Management (France)
Identical
No rebalancing of the Absorbed Sub-Fund's portfolio will be carried out prior the Merger.
<i>Profile of typical investor
i>The Absorbed Sub-Funds is suitable for the investor who can set aside the invested capital for at least five years, ideally
ten years. The Absorbing Sub-Fund is aimed at investors who wish to withdraw their money over a five-year-time period,
ideally ten-year-time period and are prepared to take the higher risks associated with equity investments for the aim of
maximising the return and are able to accept significant temporary losses. The Absorbed and the Absorbing Sub-Fund do
not differ with regard to the profile of typical investor.
<i>Distribution policy
i>The distribution policy is the same for the Absorbed Sub-Fund and the Absorbing Sub-Fund.
<i>Fees and expenses
i>Fees, costs or any other charges applicable in the Absorbing Sub-Fund will not change after the merger.
<i>Minimum initial investment
i>The minimum initial investment for the above share class of the Absorbing Sub-Fund is the same as or compatible with
those applicable to the share classes of the Absorbed Sub-Fund.
Criteria for valuation of assets and liabilities
For the purpose of calculating the relevant exchange ratio, the rules laid down in the Articles of Incorporation and the
prospectus of the Sicav for the calculation of the NAV will apply to determine the value of the assets and liabilities of the
Absorbed Sub-Fund and the Absorbing Sub-Fund.
Impact of the merger on shareholders of the Absorbing Sub-Fund
The merger is not expected to impact the Absorbing Sub-Fund's shareholders.
Subscriptions for or conversions to and redemptions of shares of the Absorbing Sub-Fund will not be suspended during
the merger process.
Rights of shareholders in relation to the merger
Shareholders of the Absorbed Sub-Fund holding Class I shares or Class R shares in the Absorbed Sub-Fund on the
Effective Date will automatically be issued, in exchange for their shares in the Absorbed Sub-Fund, a number of shares of
the Absorbing Sub-Fund equivalent to the number of Class R shares held in the Absorbed Sub-Fund multiplied by the
share exchange ratio which shall be calculated for each class of shares on the basis of its NAV as of 25 August 2014. In
case the application of the relevant exchange ratio does not lead to the issuance of full shares, the shareholders of the
Absorbed Sub-Fund will receive fractions of shares to one thousandth share within the Absorbing Sub-Fund.
89709
L
U X E M B O U R G
No subscription fee will be levied within the Absorbing Sub-Fund as a result of the merger.
Shareholders of the Absorbed Sub-Fund will acquire rights as shareholders of the Absorbing Sub-Fund from the Ef-
fective Date.
Shareholders of the Absorbed Sub-Fund and of the Absorbing Sub-Fund not agreeing with the merger will be given
the possibility to request the redemption or the conversion of their shares of the Absorbed Sub-Fund and/or the Ab-
sorbing Sub-Fund into shares of that same or a different class of another sub-fund of the Sicav at the applicable NAV of
the relevant shares, without any redemption or conversion charges (other than charges retained by the Sicav to meet
disinvestment costs) during at least 30 calendar days following the date of sending out of the notice to shareholders.
Impact of the merger on the portfolio of the Absorbing Sub-Fund
The merger is not expected to impact the Absorbing Sub-Fund's portfolio.
Procedural aspects
<i>No shareholder vote required
i>No shareholder vote is required in order to carry out the merger under article 24 of the Articles of Incorporation of
the Sicav. Shareholders of the Absorbed Sub-Fund and of the Absorbing Sub-Fund not agreeing with the merger may
request the redemption or the conversion of their shares as stated under section "Rights of shareholders in relation to
the merger" prior to 18 August 2014.
<i>Suspensions in dealings
i>In order to implement the procedures needed for the merger in an orderly and timely manner, the Board of Directors
has decided that:
* Subscriptions for or conversions to and redemption of shares of the Absorbed Sub-Fund will no longer be accepted
or processed from 18 August 2014; and
* Subscriptions for or conversions to and redemptions of shares of the Absorbing Sub-Fund will not be suspended
during the merger process.
<i>Confirmation of merger
i>Each shareholder in the Absorbed Sub-Fund will receive a notification confirming (i) that the merger has been carried
out and (ii) the number of shares of the Absorbing Sub-Fund that they hold after the merger.
<i>Publications
i>The merger and its Effective Date shall be announced in the Luxembourg official journal (Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations) before the Effective Date. This information shall also be made publicly available, when regulatory
mandatory, in other jurisdictions where shares of the Absorbed Sub-Fund and the Absorbing Sub-Fund are distributed.
<i>Approval by competent authorities
i>The merger has been approved by the CSSF which is the competent authority supervising the Sicav in Luxembourg.
Costs of the merger
The management company of the Sicav will bear the legal, advisory and administrative costs and expenses associated
with the preparation and completion of the merger.
Taxation
The merger of the Absorbed Sub-Fund into the Absorbing Sub-Fund may have tax consequences for shareholders.
Shareholders should consult their professional advisers about the consequences of this merger on their individual tax
position.
Additional information
<i>Merger reports
i>PricewaterhouseCoopers Société coopérative, Luxembourg, the authorised auditor of the Sicav in respect of the
merger, will prepare reports on the merger which shall include a validation of the following items:
1) the criteria adopted for valuation of the assets and/or liabilities for the purposes of calculating the exchange ratio;
2) the calculation method for determining the exchange ratio; and
3) the final exchange ratio.
The merger report regarding items 1) and 2) above shall be made available at the registered office of the Sicav on
request and free of charge to the shareholders of the Absorbed Sub-Fund and of the Absorbing Sub-Fund and the CSSF
from the Effective Date.
<i>Additional documents available
i>The following documents are available at the registered office of the Sicav on request and free of charge to the
shareholders of the Absorbed Sub-Fund and of the Absorbing Sub-Fund:
89710
L
U X E M B O U R G
- the merger project drawn-up by the Board of Directors containing detailed information on the merger, including the
calculation method of the share exchange ratio (the "Merger Project");
- a statement by the custodian bank of the Sicav confirming that they have verified compliance of the Merger Project
with the terms of the law of 17 December 2010 on undertakings for collective investment and the articles of incorporation
of the Sicav;
- the prospectus of the Sicav; and
- the key investor information documents of the Absorbed Sub-Fund and the Absorbing Sub-Fund. The Board of
Directors draws the attention of the shareholders of the Absorbed Sub-Fund to the desirability of reading the KIID of
the Absorbing Sub-Fund before making any decision in relation to the merger.
Please contact your financial adviser or the registered office of the Sicav if you have questions regarding this matter.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2014097792/45/200.
Oneall Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3340 Huncherange, 36, rue de la Résistance.
R.C.S. Luxembourg B 165.908.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014067714/9.
(140078785) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2014.
Leoni-Els s.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9051 Ettelbruck, 98, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 98.504.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014067631/10.
(140079436) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2014.
Laser International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 86.814.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Extrait sincère et conforme
LASER INTERNATIONAL S.A.
Référence de publication: 2014067628/11.
(140078551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2014.
Key Plastics Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 812.456,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 68.568.
Afin de bénéficier de l'exemption de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion,
prévue par l'article 316 de la loi sur les sociétés commerciales, les comptes consolidés au 31 décembre 2013 de sa société
mère, Key Plastics L.L.C. ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 mai 2014.
Référence de publication: 2014067604/12.
(140078739) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2014.
89711
L
U X E M B O U R G
LUX-EURO-Trade Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4461 Belvaux, 45, rue de Hussigny.
R.C.S. Luxembourg B 60.175.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014067639/10.
(140078592) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2014.
Luxtronique, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9746 Drauffelt, 2-A, Wëltzerstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 167.068.
Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Référence de publication: 2014067640/10.
(140078962) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2014.
Monier Special Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 148.559.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 avril 2014.
Référence de publication: 2014067652/10.
(140078727) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2014.
PineBridge Alternative Investments Fund SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV -
Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 180.415.
<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d'administration le 24 avril 2014:i>
Le Conseil d'administration a coopté avec effet au 22 avril 2014 et jusqu'à la prochaine assemblée générale des ac-
tionnaires:
- M. Alain Guérard, né le 19 janvier 1968 à Sainte Adresse, France ayant son adresse professionnelle au 24, rue
Beaumont, L-1219 Luxemburg, Grand-Duché du Luxemburg (en remplacement de Jerôme Wigny, démissionnaire).
Le conseil d'administration de la Société se compose dorénavant comme suit:
- M. Alain Guérard, administrateur
- M. Kamala Anantharam, administrateur
- M. Roman Hackelsberger, administrateur
- M. George Homig, administrateur
- M. David Giroux, administrateur
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour PineBridge Alternative Investments Fund SICAV – SIF
Un mandatairei>
Référence de publication: 2014069937/22.
(140081763) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2014.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
89712
Aberro S.A.
ADEPA Asset Management S.A.
Allianz Infrastructure Luxembourg Holdco II S.A.
Allianz Infrastructure Luxembourg Holdco I S.A.
D3fine S.à r.l.
Dexia Luxpart
DWS FlexPension
DWS Funds
DWS Institutional
Feri Trust (Luxembourg) S.A.
FPM Funds
Gresham Borehamwood IP S. à r.l.
I-Space S.à r.l.
Key Plastics Europe S.à r.l.
Largam S.A.
Laser International S.A.
Leoni-Els s.à.r.l.
Luxembourg Contact Centers S.à r.l.
LUX-EURO-Trade Sàrl
Luxtronique
Monier Special Holdings S.à r.l.
Neunheuser S.à r.l.
OAK International S.A.
Octave Investissement S.A.
Oneall Sàrl
Payment Consultants S.à r.l.
PineBridge Alternative Investments Fund SICAV-SIF
Quirk Capital S.à r.l.
Rasec International Holding
Swiss Life Funds (Lux)
Swiss Life Funds (Lux)
Swiss Life Funds (Lux)
Telpro Communications (Luxembourg) S.A.
Trilantic Events Management S.à r.l.
VCK Lease S.A.
Zencap Global S.à r.l.