This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1792
10 juillet 2014
SOMMAIRE
Aerium Place de Paris S.à r.l. . . . . . . . . . . .
85974
Argos S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85984
Ascot Luxembourg Holdings 1 S.à r.l. . . . .
85985
Bellroad Investments (Luxembourg) S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85972
BRE/Eschborn III Manager S.à.r.l. . . . . . . . .
85970
BRE/Eschborn IV Manager S.à.r.l. . . . . . . . .
85971
BRE/Eschborn V Manager S.à.r.l. . . . . . . . .
85972
BRE/Essen II Manager S.à.r.l. . . . . . . . . . . . .
85973
BRE/Essen I Manager S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . .
85977
BRE/Munich IV Manager S.à.r.l. . . . . . . . . . .
85999
Bull Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85971
Buro-Lietaer S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85970
Cabinet Comptable et Fiscal du Sud S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85976
Cabot NHUMO Holdings I S.à r.l. . . . . . . .
85971
Canoubi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85977
Canoubi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85976
Catalis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85972
CETP Co-Investment S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
85971
CLdN Bulk II S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85976
CMB Global Lux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85999
Coiffure NOSBUSCH S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
85972
Comenius Trading and Consulting S.A. . .
85974
Compagnie Financière S.A. . . . . . . . . . . . . .
86015
Concept.Com S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85974
C.O.R.A. Soparfi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85970
Créa-Tifs Coiffure S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
85974
Credit Suisse Fund Services (Luxembourg)
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85970
Ekdhall SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85977
Fil'eau S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86013
Haus & Garten Service S.à r.l. . . . . . . . . . . .
86011
Kato S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85976
Kite Fund Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85977
Melchior Selected Trust . . . . . . . . . . . . . . . .
85973
M&S Coiffure s. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85973
Nylda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85998
Simran Mediatech S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
86008
Synergryn S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86016
Tappa Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85975
Technical Concepts Luxembourg . . . . . . . .
86009
Temma S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85975
Vector Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
85975
WSHP GP S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85999
Yluv S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85978
85969
L
U X E M B O U R G
BRE/Eschborn III Manager S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 96.448.
Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014063998/9.
(140075076) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2014.
Buro-Lietaer S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.
R.C.S. Luxembourg B 74.501.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014064010/10.
(140074454) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2014.
C.O.R.A. Soparfi S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 2, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 117.546.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014064011/10.
(140074452) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2014.
Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 45.727.
Suite à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 2 mai 2014, le conseil d'administration se compose dès à
présent et ce jusqu'à la fin de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2015, comme
suit:
- Jean-Paul Gennari, Membre du Conseil d'Administration
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
- Rudolf Kömen, Membre du Conseil d'Administration
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
- Yves Maas, Membre du Conseil d'Administration
56, Grand-rue, L-1660 Luxembourg
- Christian Schärer, Membre du Conseil d'Administration
5, Kalanderplatz, CH-8045 Zurich
- Daniel Siepmann, Membre du Conseil d'Administration
5, Kalanderplatz, CH-8045 Zurich
En date du 2 mai 2014, le conseil d'administration a réélu KPMG Luxembourg S.à r.l., comme réviseur d'entreprises
et ce jusqu'à la fin de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mai 2014.
CREDIT SUISSE FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
Référence de publication: 2014065689/25.
(140076491) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2014.
85970
L
U X E M B O U R G
BRE/Eschborn IV Manager S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 96.449.
Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014063999/9.
(140074389) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2014.
Cabot NHUMO Holdings I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 179.879.
Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de rési-
dence à Esch/Alzette, en date du 12 novembre 2013 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 12 décembre 2013.
Référence de publication: 2014064012/11.
(140074942) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2014.
CETP Co-Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 114.415.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue à Luxembourg le 28 avril 2014:i>
Il résulte des décisions de l'assemblée générale annuelle de la Société du 28 avril 2014 que le mandat du réviseur
d'entreprise Ernst & Young n'est pas renouvelé.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 08 mai 2014.
CETP Co-Investment S.à r.l.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2014064065/14.
(140074943) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2014.
Bull Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 91.846.
<i>Extrait des délibérations de l'Assemblée Générale Ordinaire du 7 mai 2014i>
L'Assemblée Générale renomme:
- Nico THILL, Président;
- Giorgio BAROFFIO, Administrateur;
- Cristiano CORTELLA, Administrateur;
- Florence PILOTAZ, Administrateur.
Leurs mandats respectifs prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 dé-
cembre 2014.
L'Assemblée Générale renomme comme réviseur d'entreprises agréé:
- PricewaterhouseCoopers.
Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mai 2014.
Référence de publication: 2014065634/20.
(140077028) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2014.
85971
L
U X E M B O U R G
BRE/Eschborn V Manager S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 96.450.
Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014064000/9.
(140074388) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2014.
Coiffure NOSBUSCH S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5601 Mondorf-les-Bains, Domaine Thermal.
R.C.S. Luxembourg B 51.481.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014064022/10.
(140074450) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2014.
Catalis, Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 123, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 85.295.
Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fiduciaire Arbo S.A.
Signature
Référence de publication: 2014064057/11.
(140075200) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2014.
Bellroad Investments (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 165.742.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale de la Société tenue en date du 22 janvier 2014i>
En date du 22 janvier 2014, l'assemblée générale de la Société a pris les résolutions suivantes:
- d'accepter la démission Monsieur Gilbert RIBEIRA de son mandat de gérant de la Société avec effet immédiat;
- d'accepter la démission Monsieur Laurent SCHYNS de son mandat de gérant de la Société avec effet immédiat;
- de nommer Monsieur Michel PRIESTER, né le 17 février 1968 à Thionville, France, résidant professionnellement à
l'adresse suivante: 10A, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, en tant que nouveau gérant de la Société avec effet
immédiat et ce pour une durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale de la Société qui se tiendra en l'année 2018;
- de nommer Monsieur Daniel WAINBERG, né le 23 août 1968 à Montevideo, Uruguay, résidant professionnellement
à l'adresse suivante: 70, rue du Rhône, CH-1204 Genève, Suisse, en tant que nouveau gérant de la Société avec effet
immédiat et ce pour une durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale de la Société qui se tiendra en l'année 2018;
- de renouveler le de Monsieur Fernando BATISTA en tant que gérant de la Société avec effet immédiat et ce pour
une durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale de la Société qui se tiendra en l'année 2018.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 mai 2014.
Bellroad Investments (Luxembourg) S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2014064809/24.
(140076208) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2014.
85972
L
U X E M B O U R G
BRE/Essen II Manager S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 96.577.
Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014064002/9.
(140074386) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2014.
M&S Coiffure s. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2351 Luxembourg, 1, rue des Primevères.
R.C.S. Luxembourg B 125.262.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014065145/10.
(140075975) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2014.
Melchior Selected Trust, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 114.615.
<i>Extraits des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire, tenue à Luxembourg le 10 Avril 2014:i>
- L'Assemblée Générale Ordinaire décide:
* de renouveler le mandat des Administrateurs pour une période d'un an prenant fin avec l'Assemblée Générale
Ordinaire qui se tiendra en 2015:
- Mr. Ulrich LICHTENBERG, Président du Conseil d'Administration et Administrateur
- Mr. Magnus SPENCE, Administrateur
- Mr. Geoffroy LINARD DE GUERTECHIN, Administrateur
- Mr. Richard JONES, Administrateur
- Mr. Niccolo CAISSOTTI DI CHIUSANO, Administrateur
* de renouveler le mandat de KPMG Luxembourg S.à r.l. en tant que Réviseur d'Entreprises Agrée de la Société pour
une période d'un an prenant fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2015.
A l'issue de l'Assemblée Générale, le Conseil d'Administration est composé de:
<i>Président et Administrateur du Conseil d'Administration:i>
- Mr. Ulrich LICHTENBERG.
<i>Administrateurs:i>
- Mr. Magnus SPENCE;
- Mr. Geoffroy LINARD DE GUERTECHIN;
- Mr. Richard JONES;
- Mr. Niccolo CAISSOTTI DI CHIUSANO.
<i>Le Réviseur d'Entreprises Agréé:i>
KPMG Luxembourg S.à r.l.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE
Société Anonyme
Référence de publication: 2014065151/31.
(140075961) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2014.
85973
L
U X E M B O U R G
Concept.Com S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 145.728.
Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour le Conseil d’administrationi>
Référence de publication: 2014064032/10.
(140074672) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2014.
Créa-Tifs Coiffure S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8510 Redange-sur-Attert, 42, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 158.749.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014064035/10.
(140074461) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2014.
CTC S.A., Comenius Trading and Consulting S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 63.088.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
COMENIUS TRADING AND CONSULTING S.A.
En abrégé: CTC SA
Référence de publication: 2014064080/11.
(140074849) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2014.
Aerium Place de Paris S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 105.171.
<i>Extrait des résolutions de l'associé uniquei>
Suite à la démission de Monsieur Franck Ruimy en sa qualité de gérant unique de la Société et suite aux résolutions
de l'associé unique de la Société prises en date du 8 avril 2014, il a été décidé de nommer Sycamore Management S.à r.l.,
une société à responsabilité limitée, constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège
social au 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 150.718, dont le capital social est fixé à EUR 12,500, en tant que gérant unique de la Société en
remplacement du gérant démissionnaire pour une durée indéterminée.
Traduction pour les besoins de l'enregistrement
Further to the resignation of Mr. Franck Ruimy as sole manager of the Company and further to the resolutions of the
sole shareholder of the Company dated 8 April 2014, it has been decided to appoint Sycamore Management S.à r.l., a
private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg, having its registered office at 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, registered with the
Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 150.718, the corporate capital of which is fixed at EUR
12,500, as sole manager of the Company in place of the resigning manager for an indefinite period.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014065519/23.
(140076494) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2014.
85974
L
U X E M B O U R G
Temma S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 177.639.
La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date
du 23 mai 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1726 du 18 juillet 2013.
Les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Temma S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2014065326/14.
(140075812) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2014.
Tappa Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 164.850.
EXTRAIT
Par résolutions prises en date du 31 mars 2014, le conseil de gérance de Tappa Holding S.à r.l. a transféré le siège
social de la société au 2-8 Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, avec effet au 31 mars 2014.
Par ailleurs, les gérants de la société ont changé d'adresse professionnelle comme suit:
- M. Christophe Ponticello a désormais pour adresse professionnelle le 2-8 Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Lu-
xembourg; et
- M. Simon Henin a désormais pour adresse professionnelle le 2-8 Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 9 mai 2014.
Référence de publication: 2014065333/17.
(140076309) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2014.
Vector Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 352.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 132.303.
L'adresse professionnelle de M. Simon Barnes, gérant de la Société est désormais au 15, Jean -Pierre Brasseur, L-1258
Luxembourg.
<i>Extrait des résolutions prises par les associés de la Société en date du 6 mai 2014:i>
Les associés de la Société ont pris les résolutions suivantes:
- Nomination de M. Frits Carlsen, résidant professionnellement au 47, avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg,
Grand Duché de Luxembourg, né le 4 septembre 1958 à Copenhague, Danemark en qualité de gérant avec effet au 30
avril 2014 et pour une durée indéterminée (en remplacement de Mme Deniz Erkus, démissionnaire).
- Nomination de M. Sanjeev Jewootah, résidant professionnellement au 9A, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxem-
bourg, Grand Duché de Luxembourg, né le 29 décembre 1975 à Forest-Side, Maurice en qualité de gérant avec effet au
30 avril 2014 et pour une durée indéterminée (en remplacement de M. Jens Hoellermann, démissionnaire)
Le conseil de gérance se compose dorénavant comme suit:
- M. Simon Barnes, gérant
- M. Frits Carlsen, gérant
- M. Sanjeev Jewootah, gérant
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014065367/23.
(140075367) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2014.
85975
L
U X E M B O U R G
Cabinet Comptable et Fiscal du Sud S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4081 Esch-sur-Alzette, 37, rue Dicks.
R.C.S. Luxembourg B 56.464.
Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014064041/10.
(140075156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2014.
CLdN Bulk II S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 3-7, rue Schiller.
R.C.S. Luxembourg B 160.577.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
P. Traen / M. Jadot
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2014064069/11.
(140074496) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2014.
Canoubi S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 97.582.
Le siège social de la société CANOUBI S.A., RCS Luxembourg B 97582 (L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre
Brasseur), a été dénoncé avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 avril 2014.
FELTEN & ASSOCIES
Signature
<i>L'agent domiciliatairei>
Référence de publication: 2014064046/13.
(140074640) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2014.
Kato S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: EUR 75.000,00.
Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 134.967.
EXTRAIT
Il résulte d'un contrat de transfert de parts sociales signé le 23 avril 2014 que Sea Jewel Investments Limited, associé
unique de la Société, a transféré avec effet au 8 mai 2014:
- soixante-et-onze mille cent soixante-quinze (71.175) parts sociales détenues dans le capital social de la Société à
METRO Group Retail Real Estate GmbH, une société à responsabilité limitée ayant son siège social à Albertussee 1, 40549
Düsseldorf, Allemagne, et immatriculée auprès du Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf sous le numéro HRB
61413;
- trois mille huit cent vingt-cinq (3.825) parts sociales détenues dans le capital social de la Société à Wisteria Investment
Management S.à r.l., une société à responsabilité limité ayant son siège social au 13, Schlappgaass, L-9365 Eppeldorf, Grand-
duché de Luxembourg, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B186524.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mai 2014.
Référence de publication: 2014065902/20.
(140076555) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2014.
85976
L
U X E M B O U R G
BRE/Essen I Manager S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 96.576.
Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014064001/9.
(140074387) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2014.
Canoubi S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 97.582.
Par la présente, je suis au regret de vous annoncer ma démission de mes fonctions d'administrateur et de Président
du conseil d'administration de votre société, avec effet immédiat.
Luxembourg, le 28 avril 2014.
Bernard FELTEN.
Référence de publication: 2014064047/10.
(140075070) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2014.
Ekdhall SA, Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1836 Luxembourg, 23, rue Jean Jaurès.
R.C.S. Luxembourg B 83.657.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire reportée du 22 avril 2014i>
Le mandat des administrateurs Michaël Dandois, Antoine Meynial et Olivia Kirsch est reconduit jusqu'à l'assemblée
devant se tenir en 2019.
Le mandat du commissaire aux comptes Chester & Jones est reconduit jusqu'à l'assemblée devant se tenir en 2019.
L'assemblée note son changement d'adresse au 14, rue Bernard Haal, L-1711 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dandois & Meynial
Référence de publication: 2014064129/14.
(140074901) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2014.
Kite Fund Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 171.354.
<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 15 avril 2014i>
- Nomination de Lidia PALUMBO, demeurant professionnellement au 32-36 Boulevard d'Avranches, L-1160 Luxem-
bourg, en tant que nouvel Administrateur et Président du Conseil d'Administration pour une période d'un an se terminant
avec la prochaine assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2015.
- Nomination de Tesfamicael MEHRETAB, demeurant professionnellement au 11 rue Béatrix de Bourbon, L-1225
Luxembourg, en tant que nouvel Administrateur et pour une période d'un an se terminant avec la prochaine assemblée
générale ordinaire qui se tiendra en 2015.
- Renouvellement du mandat des administrateurs suivants pour une période d'un an se terminant avec la prochaine
assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2015:
* M. Roberto FACCHINI, Administrateur
* M. Stefano FORMENTINI, Administrateur
- Renouvellement du mandat de PricewaterhouseCoopers, Réviseur d'Entreprises Agréé, 400 route d'Esch, L-1471
Luxembourg, pour une période d'un an prenant fin à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014065909/21.
(140077260) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2014.
85977
L
U X E M B O U R G
Yluv S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 186.810.
STATUTES
In the year two thousand fourteen, on the twenty-ninth of April.
Before the undersigned Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg.
There appeared:
1) Mrs Monika MANDL, company director, residing at Glasergasse 21, 1090 Vienna, Austria, represented.
2) Mr Michael NAGY, company director, residing at Negerlegasse 2, 1020 Vienna, Austria, in person.
Mr Michael NAGY appears on his own name and also on behalf of Mrs Monika MANDL, acting by virtue of a proxy
given under private seal which, signed "ne varietur" by Mr NAGY and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed for the purpose of registration.
Such appearing parties, acting in the above stated capacities, have drawn up the following articles of a limited liability
company to be organized among themselves.
Art. 1. A private limited liability company is hereby formed between the contracting parties that will be governed by
these articles and by the relevant legislation.
The name of the company is “YLUV S.à r.l.”.
Art. 2. The registered office is established in Luxembourg-City.
It may be transferred to any other place within the Grand-Duchy of Luxembourg by collective decision of the members.
Art. 3. The company is established for an unlimited period.
Art. 4. The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining to the taking of participating
interests in any enterprises in Luxembourg or abroad in whatever form, as well as the administration, the management,
the control and the development of such participating interests.
The company may particularly purchase, trade or otherwise invest in shares, corporate units and any participating
interests, loans, bonds or other debt instruments or securities and in general securities and financial instruments which
are issued by a public or private company, borrow, lend from/to its subsidiaries or companies in which it has a direct or
indirect interest, including the issue of bonds, promissory notes or other securities or evidence of indebtedness, as well
as to enter into agreements in connection with the aforementioned.
The company may borrow in any form whatever. The company may grant to the companies of the group or to its
shareholders, any support, loans, advances or guarantees.
The company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly
or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.
Art. 5. The share capital of the Company is fixed at twelve thousand and five hundred euro (EUR 12,500.-) represented
by twelve thousand and five hundred (12,500) shares having a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, divided as follows
into ten (10) classes of shares:
1. One thousand two hundred and fifty (1,250) shares of Class A, the “Class A” shares;
2. One thousand two hundred and fifty (1,250) shares of Class B, the “Class B” shares;
3. One thousand two hundred and fifty (1,250) shares of Class C, the “Class C” shares;
4. One thousand two hundred and fifty (1,250) shares of Class D, the “Class D” shares;
5. One thousand two hundred and fifty (1,250) shares of Class E, the “Class E” shares;
6. One thousand two hundred and fifty (1,250) shares of Class F, the “Class F” shares;
7. One thousand two hundred and fifty (1,250) shares of Class G, the “Class G” shares;
8. One thousand two hundred and fifty (1,250) shares of Class H, the “Class H” shares;
9. One thousand two hundred and fifty (1,250) shares of Class I, the “Class I” shares;
10. One thousand two hundred and fifty (1,250) shares of Class J, the “Class J” shares;
Art. 6. The capital may be increased or reduced at any time.
Art. 7. Each share entitles its owner to a proportional right in the company's assets and profits.
Art. 8. Shares are freely transferable among members. The share transfer to non-members may only be done in
accordance with the law on commercial companies.
Art. 9. The company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of one of the members.
85978
L
U X E M B O U R G
Art. 10. For no reason and in no case, the heirs, creditors or other rightful claimants of the members are allowed to
pursue the sealing of property or documents of the company.
Art. 11. The company is managed by several managers of which at least one manager of category A and one manager
of category B. The managers are appointed and dismissed by the members.
Towards third parties, the company is in all circumstances committed by the joint signatures of one manager of category
A and one manager of category B.
Art. 12. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible. As agents of the company,
they are responsible for the correct performance of their duties.
Art. 13. Every member may take part in the collective decisions. He has a number of votes equal to the number of
shares he owns and may validly act at the meetings through a special proxy.
Art. 14. Collective decisions are only valid if they are adopted in accordance with the dispositions of the law on
commercial companies.
Art. 15. The business year begins on 1 January and ends on 31 December of each year.
Art. 16. Every year on 31 December, the annual accounts are drawn up by the managers.
Art. 17. The financial statements are at the disposal of the members at the registered office of the company.
Art. 18. At least 5% of the net profit for the financial year has to be allocated to the legal reserve fund. Such contribution
will cease to be compulsory when the reserve fund reaches 10% of the subscribed capital.
The remaining balance of the available profits may be distributed to the shareholders in the following order of priority:
- The holders of Class A shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an
amount of zero point one per cent (0.1%) of the nominal value of the Class A shares, then,
- the holders of Class B shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of zero point two per cent (0.2%) of the nominal value of the Class B shares, then,
- the holders of Class C shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of zero point three per cent (0.3%) of the nominal value of the Class C shares, then,
- the holders of Class D shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of zero point four per cent (0.4%) of the nominal value of the Class D shares, then,
- the holders of Class E shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of zero point five per cent (0.5%) of the nominal value of the Class E shares, then,
- the holders of Class F shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of zero point six per cent (0.6%) of the nominal value of the Class F shares, then,
- the holders of Class G shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of zero point seven per cent (0.7%) of the nominal value of the Class G shares, then,
- the holders of Class H shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of zero point eight per cent (0.8%) of the nominal value of the Class H shares, then,
- the holders of Class I shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of zero point nine per cent (0.9%) of the nominal value of the Class I shares, then,
- the holders of Class J shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
being the higher of (i) one per cent (1%) of the nominal value of the Class J shares or (ii) all the remainder of the net
profits and of the available reserves derived from retained earnings (once all distributions on the other classes of shares
have been made) to be distributed among the holders of Class J shares, based on their respective shareholding in the
Class J shares.
Should no Class J shares be in issue or should all the Class J shares have been cancelled following their repurchase or
otherwise at the time of the relevant distribution, the holders of shares forming the then last outstanding class of shares,
in reverse alphabetical order, shall be entitled to receive the higher of (i) its respective percentage, as indicated in this
article, or (ii) all the remainder of the net profits and of the available reserves derived from retained earnings (once all
distributions on the other classes of shares have been made), to be distributed among its holders and based on their
respective shareholding in the class of shares concerned. For the avoidance of doubt, such provision is applicable to all
the classes of shares which are still in issue at the time of the relevant distribution.
Art. 19. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for the
amendment of the Articles of Incorporation.
Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need not to be
members and who are appointed by the general meeting which will specify their powers and remuneration.
Art. 20. For anything not dealt with in the present Articles of Incorporation, the members refer to the relevant
legislation.
85979
L
U X E M B O U R G
<i>Transitory dispositioni>
The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on 31
st
December 2014.
<i>Subscription and paymenti>
The twelve thousand and five hundred (12,500) shares have been subscribed to as follows:
1) Mrs Monika MANDL, prenamed:
Six hundred twenty five (625) Class A shares;
Six hundred twenty five (625) Class B shares;
Six hundred twenty five (625) Class C shares;
Six hundred twenty five (625) Class D shares;
Six hundred twenty five (625) Class E shares;
Six hundred twenty five (625) Class F shares;
Six hundred twenty five (625) Class G shares;
Six hundred twenty five (625) Class H shares;
Six hundred twenty five (625) Class I shares;
Six hundred twenty five (625) Class J shares.
2) Mr Michael NAGY, prenamed:
Six hundred twenty five (625) Class A shares;
Six hundred twenty five (625) Class B shares;
Six hundred twenty five (625) Class C shares;
Six hundred twenty five (625) Class D shares;
Six hundred twenty five (625) Class E shares;
Six hundred twenty five (625) Class F shares;
Six hundred twenty five (625) Class G shares;
Six hundred twenty five (625) Class H shares;
Six hundred twenty five (625) Class I shares;
Six hundred twenty five (625) Class J shares.
All the shares have been entirely paid up in cash, so that the company has now at its disposal the sum of twelve thousand
and five hundred euros (EUR 12,500.-) as was certified to the notary executing this deed.
<i>Verificationi>
The notary executing this deed declares that the conditions fixed in Art. 183 of the law on Commercial Companies
of September 18, 1933 have been fulfilled.
<i>Expensesi>
The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its incorporation is approximately fixed at
1.250,- EUR
<i>Extraordinary general meetingi>
Immediately after the incorporation of the company, the appearing parties, acting in the above stated capacities, re-
presenting the whole of the corporate capital, held an extraordinary general meeting and unanimously passed the following
resolutions:
<i>First resolutioni>
Are appointed managers of category A, with the powers indicated in article 11 of the articles of incorporation:
<i>Category Ai>
- Mrs. Monika MANDL, company director, born on 29 October 1974 in Munich, Germany, residing at Glasergasse 21,
1090 Vienna, Austria.
- Mr. Michael NAGY, company director, born on 8 November 1975 in Vienna, Austria, residing at Negerlegasse 2,
1020 Vienna, Austria.
Are appointed managers of category B, with the powers indicated in article 11 of the articles of incorporation:
<i>Category Bi>
- Mr Pierre LENTZ, company director, born on 22. April 1959 in Luxembourg, residing professionally at L-1653
Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
- Mr Philippe PONSARD, company director, born on 16. March 1967 in Arlon, Belgium, residing professionally at
L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
85980
L
U X E M B O U R G
- Mr Gerdy ROOSE, company director, born on 14 February 1966 in Wevelgem, Belgium, residing professionally at
L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
The managers are elected for an undetermined period.
They may be reelected.
<i>Second resolutioni>
The company's registered office is located at L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English followed by a German version.
On request of the same appearing parties and in case of divergences between the English and the German text, the
English version will be prevailing.
The document having been read and translated into the language of the parties appearing, whom are known to the
notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, said parties appearing signed together with us,
Notary, the present original deed.
Folgt die deutsche Fassung des vorstehenden Textes:
Im Jahre zweitausendvierzehn.
Den neunundzwanzigsten Tag des Monats April,
Vor uns Maître Jean SECKLER, Notar mit Amtssitz zu Junglinster, Großherzogtum Luxemburg.
Sind erschienen:
1) Frau Monika MANDL, Verwalter, wohnhaft in Glasergasse 21, 1090 Wien, Österreich, vertreten.
2) Herr Michael NAGY, Verwalter, wohnhaft in Negerlegasse 2, 1020 Wien, Österreich, in Person.
Herr Michael NAGY erscheint sowohl in eigenem Namen als auch im Namen von Frau Monika MANDL, aufgrund
einer privatschriftlichen Vollmacht.
Die oben aufgeführte Vollmacht, nachdem sie durch Herrn NAGY und den unterzeichneten Notar "ne varietur" ge-
gengezeichnet wurde, wird zusammen mit den Gesellschaftssatzungen zur Registrierung vorgelegt.
Die erschienen Parteien, handelnd wie erwähnt, ersuchen den unterzeichneten Notar, die Satzungen einer von ihnen
zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden.
Art. 1. Die Unterzeichneten gründen hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, der sie die nachstehende
Satzung, sowie die diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde legen.
Die Gesellschaft führt die Bezeichnung „YLUV S.à r.l.“.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt.
Der Sitz kann durch Beschluss der Gesellschafter an jeden anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg verlegt
werden.
Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer errichtet.
Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist die Übernahme von Beteiligungen, Anteilen und Anteilsscheinen in Luxemburg oder
im Ausland in jeder Form gleich welcher Art sowie die Verwaltung dieser Beteiligungen, Anteile und Anteilsscheine.
Die Gesellschaft kann insbesondere durch Zeichnung, Kauf, Tausch oder in sonstiger Weise Aktien, Anteile und andere
Kapitalbeteiligungen, Anleihen, Anleihenobligationen, Einlagenzertifikate und andere schuldrechtliche Wertpapiere und
im allgemeineren Sinne alle Wertpapiere und Finanzinstrumente erwerben, die von einer Publikums- oder privaten Ge-
sellschaft gleich welcher Art ausgegeben wurden, Geld aufnehmen / Geld leihen an Tochtergesellschaften oder Gesell-
schaften, in denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, einschliesslich der Ausgabe von Obligationen, Inhaberschuldver-
schreibungen oder anderen Wertpapieren oder Schuldtiteln sowie Verträge schliessen in Bezug auf vorerwähnte
Wertpapiere.
Die Gesellschaft kann in jedweder Form Geld aufnehmen. Sie kann an verbundene Gesellschaften oder an Gesell-
schafter jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschüsse oder Garantien gewähren.
Die Gesellschaft wird alle Maßnahmen zur Wahrung ihrer Rechte ergreifen und jede Art von Geschäften abschließen,
die mit ihrem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt verbunden sind oder diesen fördern.
Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausend fünfhundert Euro (EUR 12.500.-) eingeteilt in zwölftausend fünf-
hundert (12.500) Anteile mit einem Nennwert von ein Euro (EUR 1.-) pro Anteil, fest in zehn (10) Aktienklassen unterteilt,
wie folgt:
1. Ein tausendzweihundertfünfzig (1.250) Anteile der Klasse A, der "Klasse A" Anteile;
2. Ein tausendzweihundertfünfzig (1.250) Anteile der Klasse B, der "Klasse B" Anteile;
3. Ein tausendzweihundertfünfzig (1.250) Anteile der Klasse C, der "Klasse C" Anteile;
85981
L
U X E M B O U R G
4. Ein tausendzweihundertfünfzig (1.250) Anteile der Klasse D, der "Klasse D" Anteile;
5. Ein tausendzweihundertfünfzig (1.250) Anteile der Klasse E, der "Klasse E" Anteile;
6. Ein tausendzweihundertfünfzig (1.250) Anteile der Klasse F, der "Klasse F" Anteile;
7. Ein tausendzweihundertfünfzig (1.250) Anteile der Klasse G, der "Klasse G" Anteile;
8. Ein tausendzweihundertfünfzig (1.250) Anteile der Klasse H, der "Klasse H" Anteile;
9. Ein tausendzweihundertfünfzig (1.250) Anteile der Klasse I, der "Klasse I" Anteile;
10. Ein tausendzweihundertfünfzig (1.250) Anteile der Klasse J, der "Klasse J" Anteile;
Art. 6. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit erhöht oder herabgesetzt werden, unter den in Artikel 199 des Gesetzes
über die Handelsgesellschaften festgesetzten Bedingungen.
Art. 7. Jeder Anteil ist proportional an den Aktiva und am Gewinn beteiligt.
Art. 8. Zwischen Gesellschaftern sind die Anteile frei übertragbar. Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen an Dritte
unterliegt den Bestimmungen des Gesetzes über die Handelsgesellschaften.
Art. 9. Tod, Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf.
Art. 10. Erben, Gläubiger oder andere Berechtigte können in keinem Fall einen Antrag auf Pfändung des Firmeneigen-
tums oder von Firmenschriftstücken stellen.
Art. 11. Die Gesellschaft wird durch mehreren Geschäftsführer verwaltet, von denen mindestens ein Geschäftsführer
der Kategorie A und ein Geschäftsführer der Kategorie B zugehört. Die Gesellschafter nominieren und entlassen die
Geschäftsführer.
Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift von einem Geschäftsführer der Kategorie A und einem
Geschäftsführer der Kategorie B nach außen hin verpflichtet.
Art. 12. Bei der Ausübung ihres Amtes gehen der oder die Geschäftsführer keinerlei persönliche Verpflichtungen ein.
Als Beauftragte sind sie lediglich für die ordnungsgemäße Durchführung ihres Amtes verantwortlich.
Art. 13. Jeder Gesellschafter ist in der Generalversammlung stimmberechtigt. Er hat soviel Stimmen wie er Anteile
besitzt und kann sich aufgrund einer Vollmacht an den Versammlungen rechtsgültig vertreten lassen.
Art. 14. Die entsprechenden Vorschriften des Gesetzes über die Handelsgesellschaften sind für die Beschlüsse der
Generalversammlung zu beachten.
Art. 15. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres.
Art. 16. Am 31. Dezember eines jeden Jahres erstellt die Geschäftsführung den Jahresabschluss.
Art. 17. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in den Jahresabschluss nehmen.
Art. 18. Vom Nettogewinn des Geschäftsjahres sind mindestens 5% für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu
verwenden; diese Verpflichtung gilt solange bis die gesetzliche Rücklage 10% des Gesellschaftskapitals erreicht hat.
Der Saldo des Bilanzgewinnes kann in der folgenden Reihenfolge der Priorität an die Aktieninhaber verteilt werden:
- Den Aktieninhabern der Klasse A stehen Ausschüttungen für das entsprechende Jahr, in Höhe von null Komma ein
Prozent (0,1%) des Nennwertes der Aktien der Klasse A zu, und dann,
- Den Aktieninhabern der Klasse B stehen Ausschüttungen für das entsprechende Jahr, in Höhe von null Komma zwei
Prozent (0,2%) des Nennwertes der Aktien der Klasse B zu, und dann,
- Den Aktieninhabern der Klasse C stehen Ausschüttungen für das entsprechende Jahr, in Höhe von null Komma drei
Prozent (0,3%) des Nennwertes der Aktien der Klasse C zu, und dann ,
- Den Aktieninhabern der Klasse D stehen Ausschüttungen für das entsprechende Jahr, in Höhe von null Komma vier
Prozent (0,4%) des Nennwertes der Aktien der Klasse D zu, und dann,
- Den Aktieninhabern der Klasse E stehen Ausschüttungen für das entsprechende Jahr, in Höhe von null Komma fünf
Prozent (0,5%) des Nennwertes der Aktien der Klasse E zu, und dann,
- Den Aktieninhabern der Klasse F stehen Ausschüttungen für das entsprechende Jahr, in Höhe von null Komma sechs
Prozent (0,6%) des Nennwertes der Aktien der Klasse F zu, und dann,
- Den Aktieninhabern der Klasse G stehen Ausschüttungen für das entsprechende Jahr, in Höhe von Nullpunkt sieben
Prozent (0,7%) des Nennwertes der Aktien der Klasse G zu, und dann,
- Den Aktieninhabern der Klasse H stehen Ausschüttungen für das entsprechende Jahr, in Höhe von Nullpunkt acht
Prozent (0,8%) des Nennwertes der Aktien der Klasse H zu, und dann,
- Den Aktieninhabern der Klasse I stehen Ausschüttungen für das entsprechende Jahr, in Höhe von Nullpunkt neuen
Prozent (0,9%) des Nennwertes der Aktien der Klasse I zu, und dann,
- Den Aktieninhabern der Klasse J stehen Ausschüttungen für das entsprechende Jahr, in Höhe des höheren zwischen
(i) ein Prozent (1 %) des Nennwertes der Aktien der Klasse J oder (ii) all die restlichen zur Verfügung stehenden Net-
85982
L
U X E M B O U R G
togewinne und die verfügbaren, durch Gewinnrücklagen gespeisten Reserven zu (sobald die Ausschüttungen an die
anderen Aktienklassen vorgenommen worden sind), die unter den Inhabern der Aktien der Klasse J, auf der Grundlage
ihrer jeweiligen Beteiligung an den Aktien der Klasse J verteilt wird.
Sollten, zum Zeitpunkt der Ausschüttung, keine Aktien der Klasse J mehr ausstehend sein oder sollten die Aktien der
Klasse J annulliert worden sein, nach Rückkauf oder auf andere Weise, stehen den Aktieninhabern der nächsten Aktien-
klasse, in umgekehrter alphabetischer Reihenfolge, Ausschüttungen für das entsprechende Jahr, in Höhe des höheren
zwischen (i) dem entsprechendem Prozentsatz, wie in diesem Artikel beschrieben oder (ii) all die restlichen zur Verfügung
stehenden Nettogewinne und die verfügbaren, durch Gewinnrücklagen gespeisten, Reserven zu (sobald die Ausschüt-
tungen an die anderen Aktienklassen vorgenommen worden sind), die unter den Inhabern der entsprechenden Aktien-
klasse, auf der Grundlage ihrer jeweiligen Beteiligung an den Aktien dieser Klasse verteilt wird. Um jeden Zweifel
auszuschließen, betrifft die obige Anordnung alle Aktienklassen, die zum Zeitpunkt der Ausschüttung noch ausstehend
sind.
Art. 19. Die Gesellschaft kann durch ein Beschluss während der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter
den gleichen Bedingungen gefasst werden muss wie bei Satzungsänderungen.
Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidierung durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durch-
geführt, die keine Gesellschafter sein müssen und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer Aufgaben
und Vergütungen ernannt werden.
Art. 20. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gesellschafter auf die gesetzlichen
Bestimmungen.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung und endet am 31. Dezember 2014.
<i>Kapitalzeichnungi>
Von diesem Gesellschaftskapital zeichnet:
1) Frau Monika MANDL, vorgenannt:
Sechshundertfünfundzwanzig (625) Klasse A Anteile;
Sechshundertfünfundzwanzig (625) Klasse B Anteile;
Sechshundertfünfundzwanzig (625) Klasse C Anteile;
Sechshundertfünfundzwanzig (625) Klasse D Anteile;
Sechshundertfünfundzwanzig (625) Klasse E Anteile;
Sechshundertfünfundzwanzig (625) Klasse F Anteile;
Sechshundertfünfundzwanzig (625) Klasse G Anteile;
Sechshundertfünfundzwanzig (625) Klasse H Anteile;
Sechshundertfünfundzwanzig (625) Klasse I Anteile;
Sechshundertfünfundzwanzig (625) Klasse J Anteile.
2) Herr Michael NAGY, vorgenannt:
Sechshundertfünfundzwanzig (625) Klasse A Anteile;
Sechshundertfünfundzwanzig (625) Klasse B Anteile;
Sechshundertfünfundzwanzig (625) Klasse C Anteile;
Sechshundertfünfundzwanzig (625) Klasse D Anteile;
Sechshundertfünfundzwanzig (625) Klasse E Anteile;
Sechshundertfünfundzwanzig (625) Klasse F Anteile;
Sechshundertfünfundzwanzig (625) Klasse G Anteile;
Sechshundertfünfundzwanzig (625) Klasse H Anteile;
Sechshundertfünfundzwanzig (625) Klasse I Anteile;
Sechshundertfünfundzwanzig (625) Klasse J Anteile.
Alle Anteile wurden in bar voll eingezahlt, so dass der Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12,500.-) der
Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was hiermit ausdrücklich von dem amtierenden Notar festgestellt wurde.
<i>Feststellungi>
Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen des Artikels 183 des Gesetzes über die Handelsge-
sellschaften erfüllt sind.
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen schätzungsweise 1.250,-
EUR betragen.
85983
L
U X E M B O U R G
<i>Ausserordentliche Gesellschafterversammlungi>
Sodann sind die erschienen Parteien, handelnd wie erwähnt, das gesamte Gesellschaftskapital vertretend, zu einer
Gesellschafterversammlung zusammengetreten, und haben einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Werden zu Geschäftsführer der Kategorie A ernannt mit den in Artikel 11 der Satzungen festgesetzten Befugnissen:
<i>Kategorie Ai>
- Frau Monika MANDL, Verwalter, geb. 29. Oktober 1974 in München, Deutschland, wohnhaft in Glasergasse 21, 1090
Wien, Österreich.
- Herr Michael NAGY, Verwalter, geb. 8. November 1975 in Wien, Österreich, wohnhaft in Negerlegasse 2, 1020
Wien, Österreich.
Werden zu Geschäftsführer der Kategorie B ernannt mit den in Artikel 11 der Satzungen festgesetzten Befugnissen:
<i>Kategorie Bi>
- Herr Pierre LENTZ, Verwalter, geb. 22. April 1959 in Luxemburg, mit beruflicher Anschrift in L-1653 Luxemburg,
2, avenue Charles de Gaulle.
- Herr Philippe PONSARD, Verwalter, geb. 16. März 1967 in Arlon, Belgien, mit beruflicher Anschrift in L-1653 Lu-
xemburg, 2, avenue Charles de Gaulle.
- Herr Gerdy ROOSE, Verwalter, geb. 14. Februär 1966 in Wevelgem, Belgien, mit beruflicher Anschrift in L-1653
Luxemburg, 2, avenue Charles de Gaulle.
Das Mandat der Geschäftsführer ist für unbestimmte Dauer gültig.
Sie können wiedergewählt werden.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Gesellschaft hat ihren Gesellschaftssitz in L-1653 Luxemburg, 2, avenue Charles de Gaulle.
WORÜBER die vorliegende notarielle Urkunde in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt, erstellt wurde.
Der Unterzeichnete Notar der Englisch versteht und spricht erklärt, dass, auf Antrag des Komparenten, gegenwärtige
Urkunde in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Übersetzung aufgenommen wurde.
Auf Antrag derselben Komparenten und im Falle von Unterschieden zwischen der englischen und der deutschen
Fassung, ist der englische Text vorrangig.
Und nach Vorlesung und Erklärung aller Vorstehenden an die erschienen Parteien, alle dem instrumentierenden Notar
nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrie-
ben.
Gezeichnet: Michael NAGY, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 06 mai 2014. Relation GRE/2014/1810. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2014065400/350.
(140076149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2014.
Argos S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 85.445.
<i>Extrait des décisions prises par le conseil d'administration en date du 7 avril 2014i>
Le siège social a été transféré de L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte à L-2453 Luxem-
bourg, 6, rue Eugène Ruppert.
Veuillez noter que les adresses professionnelles de Mme Katia CAMBON, présidente du conseil d'administration et
M. Sébastien ANDRE, administrateurs, se situent désormais à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
Luxembourg, le 12 mai 2014.
Pour extrait et avis sincères et conformes
<i>Pour ARGOS S.A.
i>Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.
Référence de publication: 2014065571/16.
(140076733) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2014.
85984
L
U X E M B O U R G
Ascot Luxembourg Holdings 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 186.831.
STATUTES
In the year two thousand and fourteen, on the twenty-ninth day of April.
Before the undersigned Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
OEC Holdings 4 LP, a limited partnership incorporated and existing under the laws of the Cayman Islands, having its
registered office at c/o Maples Corporate Services Limited, P.O. Box 309, Ugland House, Grand Cayman KY1-1104,
Cayman Islands, registered with the Companies Registrar of the Cayman Islands under registration number MC-49703,
duly represented by Mr. Stéphane Joly-Meunier, having his professional address in Luxembourg-City, Grand Duchy of
Luxembourg, by virtue of a proxy given.
The proxy, after having been signed ne varietur by the proxy-holder and the undersigned notary, shall remain attached
to this deed in order to be registered therewith.
Such appearing party has requested the notary to document the deed of incorporation of a société à responsabilité
limitée, which it wishes to incorporate and the articles of association of which shall be as follows:
A. Name - Duration - Purpose - Registered office
Art. 1. Name. There hereby exists among the current owners of the shares and/or anyone who may be a shareholder
in the future, a company in the form of a société à responsabilité limitée under the name of “Ascot Luxembourg Holdings
1 S.à r.l.” (the “Company”).
Art. 2. Duration. The Company is incorporated for an unlimited duration. It may be dissolved at any time and without
cause by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these
articles of association.
Art. 3. Purpose.
3.1. The Company's purpose is the creation, holding, development and realisation of a portfolio, consisting of interests
and rights of any kind and of any other form of investment in entities of the Grand Duchy of Luxembourg and in foreign
entities, whether such entities exist or are to be created, especially by way of subscription, acquisition by purchase, sale
or exchange of securities or rights of any kind whatsoever, such as any equity instruments, debt instruments, patents and
licenses, as well as the administration and control of such portfolio.
3.2. The Company may further:
- grant any form of security for the performance of any obligations of the Company or of any entity, in which it holds
a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which
forms part of the same group of entities as the Company, or of any director or any other officer or agent of the Company
or of any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested
in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company; and
- lend funds or otherwise assist any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which
the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company.
3.3. The Company may carry out all transactions, which directly or indirectly serve its purpose. Within such purpose,
the Company may especially:
- raise funds through borrowing in any form or by issuing any securities or debt instruments, including bonds, by
accepting any other form of investment or by granting any rights of whatever nature, subject to the terms and conditions
of the law;
- participate in the incorporation, development and/or control of any entity in the Grand Duchy of Luxembourg or
abroad; and
- act as a partner/shareholder with unlimited or limited liability for the debts and obligations of any Luxembourg or
foreign entities.
Art. 4. Registered office.
4.1. The Company's registered office is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2. Within the same municipality, the Company's registered office may be transferred by a resolution of the board of
managers.
4.3. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of
the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
85985
L
U X E M B O U R G
4.4. Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution
of the board of managers.
B. Share capital - Shares - Register of shareholders - Ownership and transfer of shares
Art. 5. Share capital.
5.1. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), consisting of twelve
thousand five hundred (12,500) shares having a par value of one euro (EUR 1.-) each
5.2. Under the terms and conditions provided by law, the Company's share capital may be increased or reduced by a
resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles
of association.
5.3. Any new shares to be paid for in cash will be offered by preference to the existing shareholder(s). In case of
plurality of shareholders, such shares will be offered to the shareholders in proportion to the number of shares held by
them in the Company's share capital. The board of managers shall determine the period of time during which such
preferential subscription right may be exercised. This period may not be less than thirty (30) days from the date of dispatch
of a registered letter sent to the shareholder(s), announcing the opening of the subscription. However, the general meeting
of shareholders, called to resolve upon an increase of the Company's share capital, may limit or suppress the preferential
subscription right of the existing shareholder(s). Such resolution shall be adopted in the manner required for an amend-
ment of these articles of association.
Art. 6. Shares.
6.1. The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same par value.
6.2. The Company may have one or several shareholders, with a maximum number of forty (40), unless otherwise
provided by law.
6.3. A shareholder's right in the Company's assets and profits shall be proportional to the number of shares held by
him/her/it in the Company's share capital.
6.4. The death, legal incapacity, dissolution, bankruptcy or any other similar event regarding the sole shareholder, as
the case may be, or any other shareholder shall not cause the Company's dissolution.
6.5. The Company may repurchase or redeem its own shares under the condition that the repurchased or redeemed
shares be immediately cancelled and the share capital reduced accordingly.
6.6. The Company's shares are in registered form.
6.7. Fractional shares shall have the same rights on a fractional basis as whole shares, provided that shares shall only
be able to vote if the number of fractional shares may be aggregated into one or more whole shares. If there are fractions
that do not aggregate into a whole share, such fractions shall not be able to vote.
Art. 7. Register of shareholders.
7.1. A register of shareholders will be kept at the Company's registered office, where it will be available for inspection
by any shareholder. This register of shareholders will in particular contain the name of each shareholder, his/her/its
residence or registered or principal office, the number of shares held by such shareholder, any transfer of shares, the
date of notification to or acceptance by the Company of such transfer pursuant to these articles of association as well as
any security rights granted on shares.
7.2. Each shareholder will notify the Company by registered letter his/her/its address and any change thereof. The
Company may rely on the last address of a shareholder received by it.
Art. 8. Ownership and transfer of shares.
8.1. Proof of ownership of shares may be established through the recording of a shareholder in the register of share-
holders. Certificates of the recordings in the register of shareholders will be issued and signed by the chairman of the
board of managers, by any two of its members or by the sole manager, as the case may be, upon request and at the
expense of the relevant shareholder.
8.2. The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they must
designate a single person to be considered as the sole owner of that share in relation to the Company. The Company is
entitled to suspend the exercise of all rights attached to a share held by several owners until one owner has been
designated.
8.3. The Company's shares are freely transferable among existing shareholders. Inter vivos, they may only be trans-
ferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the shareholders, including the transferor,
representing in the aggregate seventy-five per cent (75%) of the share capital at least. Unless otherwise provided by law,
the shares may not be transmitted by reason of death to non-shareholders, except with the approval of shareholders
representing in the aggregate seventy-five per cent (75%) of the voting rights of the surviving shareholders at least.
8.4. Any transfer of shares will need to be documented through a transfer agreement in writing under private seal or
in notarised form, as the case may be, and such transfer will become effective towards the Company and third parties
upon notification of the transfer to or upon the acceptance of the transfer by the Company, following which any member
of the board of managers may record the transfer in the register of shareholders.
85986
L
U X E M B O U R G
8.5. The Company, through any of its managers, may also accept and enter into the register of shareholders any transfer
referred to in any correspondence or in any other document which establishes the transferor's and the transferee's
consent.
C. General meeting of shareholders
Art. 9. Powers of the general meeting of shareholders.
9.1. The Shareholders exercise their collective rights in the general meeting of shareholders, which constitutes one of
the Company's corporate bodies.
9.2. If the Company has only one shareholder, such shareholder shall exercise the powers of the general meeting of
shareholders. In such case and to the extent applicable and where the term “sole shareholder” is not expressly mentioned
in these articles of association, a reference to the “general meeting of shareholders” used in these articles of association
is to be construed as being a reference to the “sole shareholder”.
9.3. The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles
of association.
9.4. In case of plurality of shareholders and if the number of shareholders does not exceed twenty-five (25), instead
of holding general meetings of shareholders, the shareholders may also vote by resolution in writing, subject to the terms
and conditions of the law. To the extent applicable, the provisions of these articles of association regarding general
meetings of shareholders shall apply with respect to such vote by resolution in writing.
Art. 10. Convening general meetings of shareholders.
10.1. The general meeting of shareholders of the Company may at any time be convened by the board of managers,
by the statutory auditor(s), if any, or by shareholders representing in the aggregate more than fifty per cent (50%) of the
Company's share capital, as the case may be, to be held at such place and on such date as specified in the notice of such
meeting.
10.2. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, an annual general meeting must be held in
the municipality where the Company's registered office is located or at such other place as may be specified in the notice
of such meeting. The annual general meeting of shareholders must be convened within a period of six (6) months from
closing the Company's accounts.
10.3. The convening notice for any general meeting of shareholders must contain the agenda of the meeting, the place,
date and time of the meeting, and such notice is to be sent to each shareholder by registered letter at least eight (8) days
prior to the date scheduled for the meeting.
10.4. If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they
have been informed of the agenda of the meeting, the general meeting of shareholders may be held without prior notice.
Art. 11. Conduct of general meetings of shareholders - vote by resolution in writing.
11.1. A board of the meeting shall be formed at any general meeting of shareholders, composed of a chairman, a
secretary and a scrutineer, each of whom shall be appointed by the general meeting of shareholders and who need neither
be shareholders, nor members of the board of managers. The board of the meeting shall especially ensure that the meeting
is held in accordance with applicable rules and, in particular, in compliance with the rules in relation to convening, majority
requirements, vote tallying and representation of shareholders.
11.2. An attendance list must be kept at any general meeting of shareholders.
11.3. Quorum and vote
11.3.1. Each share entitles to one (1) vote.
11.3.2. Unless otherwise provided by law or by these articles of association, resolutions of the shareholders are validly
passed when adopted by shareholders representing more than fifty per cent (50%) of the Company's share capital on first
call. If such majority has not been reached on first call, the shareholders shall be convened or consulted for a second
time. On second call, the resolutions will be validly adopted with a majority of votes validly cast, regardless of the portion
of capital represented.
11.4. A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing another person, shareholder or not,
as his/her/its proxy in writing by a signed document transmitted by mail, facsimile, electronic mail or by any other means
of communication, a copy of such appointment being sufficient proof thereof. One person may represent several or even
all shareholders.
11.5. Any shareholder who participates in a general meeting of shareholders by conference-call, video-conference or
by any other means of communication which allow such shareholder's identification and which allow that all the persons
taking part in the meeting hear one another on a continuous basis and may effectively participate in the meeting, is deemed
to be present for the computation of quorum and majority.
11.6. Each shareholder may vote at a general meeting of shareholders through a signed voting form sent by mail,
facsimile, electronic mail or by any other means of communication to the Company's registered office or to the address
specified in the convening notice. The shareholders may only use voting forms provided by the Company which contain
at least the place, date and time of the meeting, the agenda of the meeting, the proposals submitted to the resolution of
85987
L
U X E M B O U R G
the meeting as well as for each proposal three boxes allowing the shareholder to vote in favour of or against the proposed
resolution or to abstain from voting thereon by marking with a cross the appropriate box. The Company will only take
into account voting forms received prior to the general meeting of shareholders which they relate to.
11.7. The board of managers may determine all other conditions that must be fulfilled by the shareholders for them
to take part in any general meeting of shareholders.
Art. 12. Amendment of the articles of association. Subject to the terms and conditions provided by law, these articles
of association may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted by a (i) majority of
shareholders (ii) representing in the aggregate seventy-five per cent (75%) of the share capital at least.
Art. 13. Minutes of general meetings of shareholders.
13.1. The board of any general meeting of shareholders shall draw minutes of the meeting which shall be signed by the
members of the board of the meeting as well as by any shareholder who requests to do so.
13.2. The sole shareholder, as the case may be, shall also draw and sign minutes of his/her/its resolutions.
13.3. Any copy and excerpt of such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any
third party, shall be certified conforming to the original by the notary having had custody of the original deed, in case the
meeting has been recorded in a notarial deed, or shall be signed by the chairman of the board of managers, by any two
of its members or by the sole manager, as the case may be.
D. Management
Art. 14. Powers of the board of managers.
14.1. The Company shall be managed by one or several managers, who need not be shareholders of the Company. In
case of plurality of managers, the managers shall form a board of managers being the corporate body in charge of the
Company's management and representation. The Company may have several classes of managers. To the extent applicable
and where the term “sole manager” is not expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board
of managers” used in these articles of association is to be construed as being a reference to the “sole manager”.
14.2. The board of managers is vested with the broadest powers to take any actions necessary or useful to fulfill the
corporate object, with the exception of the actions reserved by law or by these articles of association to the shareholder
(s).
14.3. The Company's daily management and the Company's representation in connection with such daily management
may be delegated to one or several managers or to any other person, shareholder or not, acting alone or jointly as agent
of the Company. Their appointment, revocation and powers shall be determined by a resolution of the board of managers.
14.4. The Company may also grant special powers by notarised proxy or private instrument to any persons acting
alone or jointly as agents of the Company.
Art. 15. Composition of the board of managers. The board of managers must choose from among its members a
chairman of the board of managers. It may also choose a secretary, who needs neither be a shareholder, nor a member
of the board of managers.
Art. 16. Election and removal of managers and term of the office.
16.1. Managers shall be elected by the general meeting of shareholders, which shall determine their remuneration and
term of the office.
16.2. Any manager may be removed at any time, without notice and without cause by the general meeting of share-
holders. A manager, who is also shareholder of the Company, shall not be excluded from voting on his/her/its own
revocation.
16.3. Any manager shall hold office until its/his/her successor is elected. Any manager may also be re-elected for
successive terms.
Art. 17. Convening meetings of the board of managers.
17.1. The board of managers shall meet upon call by its chairman or by any two (2) of its members at the place indicated
in the notice of the meeting as described in the next paragraph.
17.2. Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four (24) hours
at least in advance of the date scheduled for the meeting by mail, facsimile, electronic mail or any other means of com-
munication, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons of such emergency must be indicated
in the notice. Such convening notice is not necessary in case of assent of each manager in writing by mail, facsimile,
electronic mail or by any other means of communication, a copy of such signed document being sufficient proof thereof.
Also, a convening notice is not required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior
resolution adopted by the board of managers. No convening notice shall furthermore be required in case all members
of the board of managers are present or represented at a meeting of the board of managers or in the case of resolutions
in writing pursuant to these articles of association.
85988
L
U X E M B O U R G
Art. 18. Conduct of meetings of the board of managers.
18.1. The chairman of the board of managers shall preside at all meeting of the board of managers. In his/her/its absence,
the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore.
18.2. Quorum
The board of managers can deliberate or act validly only if at least half of its members are present or represented at
a meeting of the board of managers including, if several classes of managers are appointed, at least one (1) manager of
each class of managers.
18.3. Vote
Resolutions are adopted with the approval of a majority of votes of the members present or represented at a meeting
of the board of managers. The chairman shall not have a casting vote.
18.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing any other manager as his/her/its
proxy in writing by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of communication, a copy of the appointment
being sufficient proof thereof. Any manager may represent one or several of his/her/its colleagues.
18.5. Any manager who participates in a meeting of the board of managers by conference-call, video-conference or by
any other means of communication which allow such manager's identification and which allow that all the persons taking
part in the meeting hear one another on a continuous basis and may effectively participate in the meeting, is deemed to
be present for the computation of quorum and majority. A meeting of the board of managers held through such means
of communication is deemed to be held at the Company's registered office.
18.6. The board of managers may unanimously pass resolutions in writing which shall have the same effect as resolutions
passed at a meeting of the board of managers duly convened and held. Such resolutions in writing are passed when dated
and signed by all managers on a single document or on multiple counterparts, a copy of a signature sent by mail, facsimile,
e-mail or any other means of communication being sufficient proof thereof. The single document showing all the signatures
or the entirety of signed counterparts, as the case may be, will form the instrument giving evidence of the passing of the
resolutions, and the date of such resolutions shall be the date of the last signature.
18.7. Any manager who has, directly or indirectly, a proprietary interest in a transaction submitted to the approval of
the board of managers which conflicts with the Company's interest, must inform the board of managers of such conflict
of interest and must have his/her/its declaration recorded in the minutes of the board meeting. The relevant manager
may not take part in the discussions on and may not vote on the relevant transaction. Where the Company has a sole
manager and the sole manager has, directly or indirectly, a proprietary interest in a transaction entered into between the
sole manager and the Company, which conflicts with the Company's interest, such conflicting interest must be disclosed
in the minutes recording the relevant transaction. This article 18.7 shall not be applicable to current operations entered
into under normal conditions.
Art. 19. Minutes of meetings of the board of managers.
19.1. The secretary, or if no secretary has been appointed, the chairman, shall draw minutes of any meeting of the
board of managers, which shall be signed by the chairman and by the secretary, as the case may be.
19.2. The sole manager, as the case may be, shall also draw and sign minutes of his/her/its resolutions.
19.3. Any copy and excerpt of any such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to
any third party shall be signed by the chairman of the board of managers, by any two of its members or by the sole
manager, as the case may be.
Art. 20. Dealings with third parties. The Company will be bound towards third parties in all circumstances by the joint
signatures of a class A manager and a class B manager or by the signature of the sole manager or by the joint signatures
or by the sole signature of any person(s) to whom such signatory power has been delegated by the board of managers
or by the sole manager. The Company will be bound towards third parties by the signature of any agent(s) to whom the
power in relation to the Company's daily management has been delegated acting alone or jointly, subject to the rules and
the limits of such delegation.
E. Supervision
Art. 21. Statutory auditor(s) - independent auditor(s).
21.1. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, its operations shall be supervised by one or
several statutory auditors, who may be shareholders or not.
21.2. The general meeting of shareholders shall determine the number of statutory auditors, shall appoint them and
shall fix their remuneration and term of the office. A former or current statutory auditor may be reappointed by the
general meeting of shareholders.
21.3. Any statutory auditor may be removed at any time, without notice and without cause by the general meeting of
shareholders.
21.4. The statutory auditors have an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the
Company.
85989
L
U X E M B O U R G
21.5. The statutory auditors may be assisted by an expert in order to verify the Company's books and accounts. Such
expert must be approved by the Company.
21.6. In case of plurality of statutory auditors, they will form a board of statutory auditors, which must choose from
among its members a chairman. It may also choose a secretary, who needs neither be a shareholder, nor a statutory
auditor. Regarding the convening and conduct of meetings of the board of statutory auditors the rules provided in these
articles of association relating to the convening and conduct of meetings of the board of managers shall apply.
21.7. If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d'entreprises agréé
(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies register and the
accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of statutory auditor(s) is suppressed.
F. Financial year - Profits - Interim dividends
Art. 22. Financial year. The Company's financial year shall begin on first January of each year and shall terminate on
thirty-first December of the same year.
Art. 23. Profits.
23.1. From the Company's annual net profits five per cent (5%) at least shall be allocated to the Company's legal
reserve. This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of the Company's reserve
amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.
23.2. Sums contributed to the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve, if the contributing
shareholder agrees with such allocation.
23.3. In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does
not exceed ten per cent (10%) of the share capital.
23.4. Under the terms and conditions provided by law and upon recommendation of the board of managers, the general
meeting of shareholders will determine how the remainder of the Company's annual net profits will be used in accordance
with the law and these articles of association.
Art. 24. Interim dividends - Share premium.
24.1. The board of managers or the general meeting of shareholders may proceed to the payment of interim dividends,
under the reservation that (i) interim accounts have been drawn-up showing that sufficient funds are available, (ii) the
amount to be distributed does not exceed total profits made since the end of the last financial year for which the annual
accounts have been approved, plus any profits carried forward and sums drawn from reserves available for this purpose,
less losses carried forward and any sums to be placed to reserve pursuant to the requirements of the law or of these
articles of association and (iii) the Company's auditor, if any, has stated in his/her report to the board of managers that
the first two conditions have been satisfied.
24.2. The share premium, if any, may be freely distributed to the shareholder(s) by a resolution of the shareholder(s)
or of the manager(s), subject to any legal provisions regarding the inalienability of the share capital and of the legal reserve.
G. Liquidation
Art. 25. Liquidation. In the event of the Company's dissolution, the liquidation shall be carried out by one or several
liquidators, individuals or legal entities, appointed by the general meeting of shareholders resolving on the Company's
dissolution which shall determine the liquidators'/liquidator's powers and remuneration.
H. Governing law
Art. 26. Governing law. These articles of association shall be construed and interpreted under and shall be governed
by Luxembourg law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the
law of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended.
<i>Transitional provisionsi>
1) The Company's first financial year shall begin on the date of the Company's incorporation and shall end on 31
December 2014.
2) Interim dividends may also be made during the Company's first financial year.
<i>Subscription and paymenti>
The subscriber has subscribed the shares to be issued as follows:
1) OEC Holdings 4 LP, aforementioned,
paid twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) in subscription for twelve thousand five hundred (12,500)
shares.
Total: twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) paid for twelve thousand five hundred (12,500) shares.
All the shares have been entirely paid-in in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR
12,500.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
85990
L
U X E M B O U R G
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be
borne by the Company in connection with its incorporation are estimated to be EUR 1,500.-.
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
The incorporating shareholder, representing the Company's entire share capital has passed the following resolutions.
1. The number of members of the board of managers is fixed at four (4).
2. The following persons are appointed as members of the board of managers of the Company:
a) Mrs. Allison Steiner, born on 6 May 1972 in Corpus Christi, Texas, USA, residing professionally at c/o Rhône Group
LLC, 630 Fifth Avenue, New York, NY 10111, United States of America; as class A manager of the Company;
b) Mr. Lucas Flynn, born on 20 December 1978 in La Plata, Argentinia, residing professionally at 40 Bruton Street,
London, W1J6QZ, United Kingdom, as class A manager of the Company;
c) Ms. Virginia Jennifer Strelen, born on 30 May 1977 in Bergisch Gladbach, Germany and residing professionally at 15,
rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as class B manager of the Company; and
d) Mr. Wim José August Rits, born on 14 June 1970 in Merksem, Belgium and residing professionally at 15, rue Edward
Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as class B manager of the Company.
The term of the office of the members of the board of managers shall end on the date when the general meeting of
shareholders/sole shareholder shall resolve upon the approval of the Company's accounts of the financial year 2014 or
at any time prior to such date as the general meeting of shareholders/sole shareholder may determine.
3. The address of the Company's registered office is set at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Grand Duchy of Luxem-
bourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that, on request of the appearing person,
this deed is worded in English followed by a German translation. On the request of the same appearing person and in
case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.
Whereof, this notarial deed was drawn up in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on the day named at the
beginning of this document.
The document having been read to the proxy-holder of the appearing person, the proxy-holder signed together with
the notary, this original deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes
Im Jahre zweitausend vierzehn, den neunundzwanzigsten April.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
Ist erschienen:
OEC Holdings 4 L.P., eine gemäß dem Recht der Kaimaninseln gegründete und bestehende Gesellschaft mit eingetra-
genem Sitz in c/o Maples Corporate Services Limited, P.O. Box 309, Ugland House, Grand Cayman KY1-1104,
Kaimaninseln, eingetragen im Companies Registrar unter Registernummer MC-49703,
ordnungsgemäß vertreten durch Herrn Stéphane Joly-Meunier, mit beruflicher Adresse in Luxemburg, Großherzogtum
Luxemburg, kraft einer erteilten Vollmacht.
Nachdem die Vollmacht durch den Bevollmächtigten und den unterzeichneten Notar ne varietur unterzeichnet worden
ist, soll diese dieser Urkunde angehängt bleiben, um mit derselben eingetragen zu werden.
Solch erschienene Partei hat den Notar ersucht, die Gründungsurkunde einer société à responsabilité limitée aufzu-
nehmen, welche sie gründen möchte und deren Gesellschaftsvertrag folgendermaßen lauten soll:
A. Firma - Dauer - Zweck - Eingetragener Sitz
Art. 1. Firma. Hierdurch besteht zwischen den derzeitigen Inhabern der Anteile und/oder jeder anderen Person, die
künftig Gesellschafter sein wird, eine Gesellschaft in Form einer société à responsabilité limitée unter der Firma “Ascot
Luxembourg Holdings 1 S.à r.l.” (die “Gesellschaft”).
Art. 2. Dauer. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet. Sie kann jederzeit und ohne Grund durch einen
Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden, welcher in der Weise gefasst wird wie es für eine Änderung
dieses Gesellschaftsvertrags erforderlich ist.
Art. 3. Zweck.
3.1. Gesellschaftszweck ist die Erschaffung, das Halten, die Entwicklung und Realisation eines Portfolios bestehend aus
Beteiligungen und Rechten jeglicher Art und jeder anderen Form von Investment in bestehenden oder zu gründenden
Rechtsgebilden im Großherzogtum Luxemburg und im Ausland vor allem durch Zeichnung, käuflichen Erwerb, Verkauf
oder Tausch von Wertpapieren oder Rechten jeglicher Art wie zum Beispiel von eigenkapitalähnlichen Instrumenten,
Schuldinstrumenten, Patenten und Lizenzen sowie die Verwaltung und Kontrolle eines solchen Portfolios.
3.2. Die Gesellschaft kann außerdem:
85991
L
U X E M B O U R G
- jede Art von Sicherheit für die Erfüllung jeglicher eigener Verbindlichkeiten oder von Verbindlichkeiten jedes Rechts-
gebildes, in welchem sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält oder in welches sie auf
andere Weise investiert hat oder welches derselben Unternehmensgruppe angehört wie die Gesellschaft, oder von Ver-
bindlichkeiten jedes beliebigen Geschäftsführers oder jedes anderen Organs oder Befugten der Gesellschaft oder eines
Rechtsgebildes, in welchem sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält oder in welches sie
auf andere Weise investiert hat oder welches derselben Unternehmensgruppe angehört wie die Gesellschaft, gewähren;
und
- jedem Rechtsgebilde, in welchem sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält oder in
welches sie auf andere Weise investiert hat oder welches derselben Unternehmensgruppe angehört wie die Gesellschaft,
Finanzmittel leihen oder dieses anderweitig unterstützen.
3.3. Die Gesellschaft kann jedwede Transaktionen vornehmen, welche direkt oder indirekt ihrem Zweck dienen.
Innerhalb dieses Zwecks kann die Gesellschaft insbesondere:
- Finanzmittel beschaffen, insbesondere durch Leihen in jeglicher Form oder durch Herausgabe jedes beliebigen Wert-
papiers oder Schuldpapiers, einschließlich Obligationsscheinen, durch Annahme jedes anderen Investments oder durch
Gewährung jedes beliebigen Rechts;
- sich an der Gründung, Entwicklung und/oder Kontrolle jedes Rechtsgebildes im Großherzogtum Luxemburg oder
im Ausland beteiligen; und
- als Partner/Gesellschafter mit unbeschränkter oder beschränkter Haftung für Schulden und Verbindlichkeiten jedes
beliebigen Luxemburger oder ausländischen Rechtsgebildes handeln.
Art. 4. Sitz.
4.1. Der eingetragene Sitz der Gesellschaft ist in der Stadt Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2. Innerhalb derselben Gemeinde kann der eingetragene Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Geschäftsfüh-
rerrats verlegt werden.
4.3. Er kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxem-
burg verlegt werden, welcher in der Weise gefasst wird wie es für eine Änderung dieses Gesellschaftsvertrags erforderlich
ist.
4.4. Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland
durch einen Beschluss des Geschäftsführerrats errichtet werden.
B. Stammkapital - Geschäftsanteile - Gesellschafterverzeichnis - Eigentum an und Übertragung von Ge-
schäftsanteilen
Art. 5. Stammkapital.
5.1. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) bestehend aus zwölf-
tausendfünfhundert (12.500) Geschäftsanteilen mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1,-) pro Geschäftsanteil.
5.2. Unter den gesetzlichen Bedingungen kann das Stammkapital der Gesellschaft durch einen Beschluss der Gesell-
schafterversammlung, welcher in der Weise gefasst wird wie es für eine Änderung dieses Gesellschaftsvertrags erfor-
derlich ist, erhöht oder herabgesetzt werden.
5.3. Alle neuen Geschäftsanteile, die durch Bareinlagen zu bezahlen sind, werden den bestehenden/dem bestehenden
Gesellschafter(n) zuerst angeboten. Im Falle einer Mehrheit von Gesellschaftern werden solche Geschäftsanteile den
Gesellschaftern im Verhältnis zur Anzahl der von ihnen im Stammkapital der Gesellschaft jeweils gehaltenen Geschäfts-
anteile angeboten. Der Geschäftsführerrat bestimmt den Zeitraum, während dessen dieses bevorzugte Anteilsbezugs-
recht ausgeübt werden kann. Dieser Zeitraum darf nicht weniger als dreißig (30) Tage vom Datum der Absendung eines
an die Gesellschafter/den Gesellschafter gesendeten Einschreibens betragen, welches die Eröffnung der Zeichnung an-
kündigt. Unter den gesetzlichen Bedingungen kann jedoch die Gesellschafterversammlung, welche einberufen wurde, um
über eine Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft zu bestimmen, das bevorzugte Anteilsbezugsrecht der bestehen-
den Gesellschafter/des bestehenden Gesellschafters begrenzen oder aufheben. Ein solcher Beschluss muss in der Weise
gefasst werden wie es für eine Änderung dieses Gesellschaftsvertrags erforderlich ist.
Art. 6. Geschäftsanteile.
6.1. Das Stammkapital der Gesellschaft ist in Geschäftsanteile mit jeweils demselben Nominalwert aufgeteilt.
6.2. Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei die Anzahl der Gesellschafter auf vierzig
(40) beschränkt ist, sofern sich nicht aus dem Gesetz etwas anderes ergibt.
6.3. Das Recht eines Gesellschafters auf das Vermögen und die Gewinne der Gesellschaft ist proportional zu der Anzahl
der von ihm im Stammkapital der Gesellschaft gehaltenen Geschäftsanteile.
6.4. Durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs oder ein anderes ähnliches Ereignis betref-
fend den alleinigen Gesellschafter, falls anwendbar, oder jeden anderen Gesellschafter soll die Gesellschaft nicht aufgelöst
werden.
85992
L
U X E M B O U R G
6.5. Die Gesellschaft kann ihre eigenen Geschäftsanteile zurückkaufen oder zurücknehmen, vorausgesetzt, die zurück-
gekauften oder zurückgenommenen Geschäftsanteile werden sofort gelöscht und das Stammkapital entsprechend
herabgesetzt.
6.6. Die Geschäftsanteile der Gesellschaft werden in eingetragener Form ausgegeben.
6.7. Bruchteilgeschäftsanteile sollen auf einer anteilsmäßigen Basis dieselben Rechte gewähren wie ganze Geschäfts-
anteile, wobei aufgrund von Geschäftsanteile nur dann Stimmrechte ausgeübt werden können, wenn die Anzahl der
Bruchteilgeschäftsanteile in eine oder mehrere Geschäftsanteile zusammengefasst werden können. Falls Bruchteilge-
schäftsanteile bestehen, welche nicht zu einer Geschäftsanteile zusammengefasst werden können, können aufgrund
solcher Bruchteilgeschäftsanteile keine Stimmrechte ausgeübt werden.
Art. 7. Gesellschafterverzeichnis.
7.1. Am eingetragenen Sitz der Gesellschaft wird ein Gesellschafterverzeichnis aufbewahrt, wo es durch jeden Gesell-
schafter eingesehen werden kann. Dieses Gesellschafterverzeichnis enthält insbesondere den Namen jedes Gesellschaf-
ters, seinen Wohnsitz oder eingetragenen Sitz oder Hauptsitz, die Anzahl der von diesem Gesellschafter gehaltenen
Geschäftsanteile, jede Übertragung von Geschäftsanteilen, das Datum der Mitteilung einer solchen Übertragung an die
Gesellschaft oder das Datum des Einverständnisses der Gesellschaft zu einer solchen Übertragung entsprechend diesem
Gesellschaftsvertrag sowie jedes über Geschäftsanteile gewährte Sicherungsrecht.
7.2. Jeder Gesellschafter wird der Gesellschaft durch Einschreiben seine Adresse und jede diesbezügliche Änderung
mitteilen. Die Gesellschaft kann sich auf die zuletzt von ihr erhaltene Adresse eines Gesellschafters berufen.
Art. 8. Eigentum an und Übertragung von Geschäftsanteilen.
8.1. Der Beweis des Eigentums an Geschäftsanteilen kann aufgrund der Eintragung eines Gesellschafters im Gesell-
schafterverzeichnis erbracht werden. Auf Ersuchen und auf Kosten eines Gesellschafters werden Zertifikate dieser
Eintragungen je nach Lage des Falles vom Präsidenten des Geschäftsführerrats, von zwei beliebigen seiner Mitglieder oder
vom alleinigen Geschäftsführer herausgegeben und unterzeichnet.
8.2. Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Geschäftsanteil an. Wenn ein Geschäftsanteil mehreren Per-
sonen gehört, müssen sie eine einzelne Person bezeichnen, welche im Verhältnis zur Gesellschaft als Alleineigentümer
des Geschäftsanteils angesehen werden kann. Die Gesellschaft ist berechtigt, die Ausübung aller mit einem im Eigentum
mehrerer Personen stehenden Geschäftsanteil verbundenen Rechte auszusetzen bis ein einziger Eigentümer bezeichnet
worden ist.
8.3. Die Geschäftsanteile der Gesellschaft sind unter bestehenden Gesellschaftern frei übertragbar. Sie können unter
Lebenden nur mit der durch insgesamt mindestens fünfundsiebzig Prozent (75%) des Stammkapitals repräsentierenden
Gesellschafter, einschließlich dem Zedenten, erteilten Einwilligung auf neue Gesellschafter übertragen werden. Soweit
gesetzlich nicht anders vorgesehen, können die Geschäftsanteile von Todes wegen auf Nicht-Gesellschafter nur mit Ein-
willigung der Gesellschafter übertragen werden, die insgesamt mindestens fünfundsiebzig Prozent (75%) der Stimmrechte
der überlebenden Gesellschafter repräsentieren.
8.4. Jede Übertragung von Geschäftsanteilen muss durch einen schriftlichen Übertragungsvertrag je nach Lage des
Falles in privatschriftlicher oder notarieller Form dokumentiert werden, und eine solche Übertragung wird gegenüber
der Gesellschaft und Dritten durch die Mitteilung der Übertragung an die Gesellschaft oder das Einverständnis der Ge-
sellschaft zur Übertragung wirksam, woraufhin jedes beliebige Mitglied des Geschäftsführerrats die Übertragung in das
Gesellschafterverzeichnis eintragen kann.
8.5. Die Gesellschaft kann durch jeden einzelnen ihrer Geschäftsführer auch einer solchen Übertragung zustimmen
und diese ins Gesellschafterverzeichnis eintragen, auf welche in einer Korrespondenz oder in einem beliebigen anderen
Dokument Bezug genommen wird, aus welchem die Einigung des Zedenten und des Zessionars hervorgeht.
C. Gesellschafterversammlung
Art. 9. Befugnisse der Gesellschafterversammlung.
9.1. Die Gesellschafter üben ihre kollektiven Rechte in der Gesellschafterversammlung aus, welche eines der Organe
der Gesellschaft bildet.
9.2. Wenn die Gesellschaft nur über einen einzelnen Gesellschafter verfügt, übt dieser die Befugnisse der Gesellschaf-
terversammlung aus. In einem solchen Fall, soweit anwendbar und wo der Begriff “alleiniger Gesellschafter” nicht
ausdrücklich in diesem Gesellschaftsvertrag erwähnt ist, soll ein in diesem Gesellschaftsvertrag genannter Verweis auf die
“Gesellschafterversammlung” als Verweis auf den „alleinigen Gesellschafter“gelesen werden.
9.3. Die Gesellschafterversammlung hat die ihr durch Gesetz oder durch diesen Gesellschaftsvertrag ausdrücklich
verliehenen Befugnisse.
9.4. Im Falle mehrerer Gesellschafter und falls die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, können,
statt Gesellschafterversammlungen abzuhalten, die Gesellschafter unter den gesetzlichen Bedingungen auch durch schrift-
lichen Beschluss abstimmen. In diesem Fall sollen, soweit anwendbar, die Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrags
betreffend Gesellschafterversammlungen hinsichtlich einer solchen Abstimmung durch schriftlichen Beschluss Anwendung
finden.
85993
L
U X E M B O U R G
Art. 10. Einberufung der Gesellschafterversammlung.
10.1. Die Gesellschafterversammlung kann jederzeit je nach Lage des Falles durch den Geschäftsführerrat, den/die
satzungsmäßigen Buchprüfer, falls vorhanden, oder durch Gesellschafter, die insgesamt mindestens fünfzig Prozent (50%)
des Stammkapitals der Gesellschaft repräsentieren, einberufen werden, wobei die Versammlung an dem in der Ladung
angegebenen Ort und Datum abgehalten wird.
10.2. Wenn die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, muss eine jährliche Gesellschafterver-
sammlung in der Gemeinde, in der sich der eingetragene Sitz der Gesellschaft befindet, oder an jedem anderen Ort wie
er sich aus der Ladung ergibt, abgehalten werden. Die jährliche Gesellschafterversammlung muss innerhalb eines Zeit-
raums von sechs (6) Monaten nach Abschluss der Gesellschaftskonten einberufen werden.
10.3. Die Ladung zu jeder Gesellschafterversammlung muss die Tagesordnung, den Ort, das Datum und die Uhrzeit
der Versammlung enthalten und ist per Einschreiben mindestens acht (8) Tage vor dem für die Versammlung anberaumten
Datum an jeden Gesellschafter abzusenden.
10.4. Wenn an einer Gesellschafterversammlung alle Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und erklären, dass
sie ordnungsgemäß über die Tagesordnung der Versammlung informiert worden sind, kann die Gesellschafterversamm-
lung ohne vorherige Ladung abgehalten werden.
Art. 11. Abhalten von Gesellschafterversammlungen - Abstimmung durch schriftlichen Beschluss.
11.1. In jeder Gesellschafterversammlung soll ein Rat der Versammlung gebildet werden bestehend aus einem Präsi-
denten, einem Sekretär und einem Prüfer, von denen jeder einzelne durch die Gesellschafterversammlung ernannt wird
und welche weder Gesellschafter noch Mitglieder der Geschäftsführung sein müssen. Der Rat der Versammlung soll
insbesondere sicherstellen, dass die Versammlung gemäß den anwendbaren Regeln und speziell im Einklang mit den Regeln
über Ladung, Mehrheitserfordernisse, Stimmauszählung und Vertretung von Gesellschaftern abgehalten wird.
11.2. In jeder Gesellschafterversammlung muss eine Anwesenheitsliste geführt werden.
11.3. Quorum und Stimmabgabe
11.3.1. Jeder Geschäftsanteil gewährt eine (1) Stimme.
11.3.2. Sofern sich aus dem Gesetz oder aus diesem Gesellschaftsvertrag nicht etwas anderes ergibt, werden Gesell-
schafterbeschlüsse bei der ersten Abstimmung wirksam gefasst, wenn sie von Gesellschaftern angenommen werden,
welche mehr als fünfzig Prozent (50%) des Stammkapitals der Gesellschaft repräsentieren. Wenn diese Mehrheit bei der
ersten Abstimmung nicht erreicht worden ist, werden die Gesellschafter ein zweites Mal geladen oder befragt. Bei der
zweiten Abstimmung werden die Beschlüsse ungeachtet des vertretenen Anteils am Kapital mit einer Mehrheit der gültig
abgegebenen Stimmen wirksam gefasst.
11.4. Ein Gesellschafter kann an jeder beliebigen Gesellschafterversammlung teilnehmen, indem er eine andere Person,
Gesellschafter oder nicht, durch ein unterzeichnetes Dokument, das auf dem Postweg, per Faxschreiben, per E-Mail oder
durch jedwedes andere Kommunikationsmittel übermittelt wird, schriftlich bevollmächtigt, wobei eine Kopie einer sol-
chen Bevollmächtigung hinreichender Beweis dafür ist. Eine Person kann mehrere oder sogar alle Gesellschafter vertreten.
11.5. Es wird vermutet, dass ein Gesellschafter, der an einer Gesellschafterversammlung durch Telefonkonferenz,
Videokonferenz oder durch ein anderes Kommunikationsmittel teilnimmt, welches es ermöglicht, dass dieser Gesell-
schafter identifiziert werden kann und dass sich alle Personen, die an der Versammlung teilnehmen, gegenseitig durch-
gehend hören und sich effektiv an der Versammlung beteiligen können, für die Zusammensetzung von Quorum und
Mehrheit anwesend ist.
11.6. Jeder Gesellschafter kann seine Stimme in einer Gesellschafterversammlung durch ein unterzeichnetes Stimm-
formular, welches per Post, Faxschreiben, E-Mail oder durch jedes anderes Kommunikationsmittel an den eingetragenen
Sitz der Gesellschaft oder an die in der Ladung genannte Adresse gesendet wird, abgeben. Die Gesellschafter können nur
solche Stimmformulare verwenden, die von der Gesellschaft zur Verfügung gestellt werden und zumindest den Ort, das
Datum und die Uhrzeit der Versammlung, die Tagesordnung, die Beschlussvorschläge an die Versammlung sowie für jeden
Vorschlag drei Kästchen enthalten, die es dem Gesellschafter ermöglichen, seine Stimme zugunsten oder gegen den
vorgeschlagenen Beschluss abzugeben oder sich zu enthalten, indem er das entsprechenden Kästchen ankreuzt. Die Ge-
sellschaft wird nur solche Stimmformulare berücksichtigen, die sie vor der Gesellschafterversammlung, auf die sie sich
beziehen, erhalten hat.
11.7. Der Geschäftsführerrat kann alle anderen Bedingungen bestimmen, die von den Gesellschaftern erfüllt werden
müssen, damit sie an Gesellschafterversammlungen teilnehmen können.
Art. 12. Änderung des Gesellschaftsvertrags. Unter den gesetzlichen Bedingungen kann dieser Gesellschaftsvertrag
durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung abgeändert werden, welcher von einer (i) Mehrheit der Gesell-
schafter, (ii) die mindestens insgesamt fünfundsiebzig Prozent (75%) des Stammkapitals der Gesellschaft repräsentieren,
gefasst wird.
Art. 13. Protokoll von Gesellschafterversammlungen.
13.1. Der Rat der Versammlung muss ein Protokoll der Versammlung aufnehmen, welches von seinen Mitgliedern
sowie von jedem Gesellschafter, der das ersucht, unterzeichnet wird.
85994
L
U X E M B O U R G
13.2. Der alleinige Gesellschafter, soweit anwendbar, muss ebenfalls ein Protokoll über die von ihm gefassten Be-
schlüsse aufnehmen und unterzeichnen.
13.3. Jede Kopie und jeder Auszug solcher originalen Protokolle, welche in Gerichtsverfahren verwendet werden sollen
oder welche einem Dritten zugänglich gemacht werden sollen, müssen, wenn die Versammlung in einer notariellen Ur-
kunde aufgenommen wurde, von dem Notar, der die Originalurkunde aufgenommen hat, beglaubigt werden, oder müssen
je nach Lage des Falles durch den Präsidenten des Geschäftsführerrats, durch zwei beliebige seiner Mitglieder oder durch
den alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet werden.
D. Geschäftsführung
Art. 14. Befugnisse des Geschäftsführerrats.
14.1. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer verwaltet, die nicht zugleich Gesellschafter sein
müssen. Im Falle von mehreren Geschäftsführern bilden diese einen Geschäftsführerrat, der das zur Geschäftsführung
und Vertretung der Gesellschaft befugte Gesellschaftsorgan ist. Die Gesellschaft kann verschiedene Klassen von Ge-
schäftsführern haben. Soweit anwendbar und wo der Begriff “alleiniger Geschäftsführer” nicht ausdrücklich in diesem
Gesellschaftsvertrag erwähnt ist, soll ein in diesem Gesellschaftsvertrag genannter Verweis auf den “Geschäftsführerrat”
als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer” gelesen werden.
14.2. Der Geschäftsführerrat verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, die zur
Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme der durch Gesetz oder durch diesen
Gesellschaftsvertrag den Gesellschaftern/dem Gesellschafter vorbehaltenen Handlungen.
14.3. Die Führung des Tagesgeschäfts der Gesellschaft und die Vertretung innerhalb dieser Führung des Tagesgeschäfts
können einem oder mehreren Geschäftsführern oder anderen Personen, ob sie Gesellschafter sind oder nicht, allein oder
gemeinschaftlich übertragen werden. Ihre Ernennung, Abberufung und ihre Befugnisse werden durch Beschluss des Ge-
schäftsführerrats festgesetzt.
14.4. Die Gesellschaft kann notariell oder durch privatschriftliche Urkunde auch spezielle Vollmachten an jedwede
Person erteilen, die alleine oder gemeinschaftlich mit anderen als Beauftragter der Gesellschaft handeln soll.
Art. 15. Zusammensetzung des Geschäftsführerrats. Der Geschäftsführerrat muss aus seiner Mitte einen Präsidenten
des Geschäftsführerrats wählen. Er kann auch einen Sekretär ernennen, der weder Gesellschafter noch Mitglied des
Geschäftsführerrats sein muss.
Art. 16. Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern und Ende der Amtszeit.
16.1. Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung gewählt, welche deren Bezahlung und Amtszeit
festlegt.
16.2. Jeder Geschäftsführer kann jederzeit, fristlos und ohne Grund durch die Gesellschafterversammlung abberufen
werden. Ein Geschäftsführer, der zugleich Gesellschafter ist, ist nicht von der Abstimmung über seine eigene Abberufung
ausgeschlossen.
16.3. Jeder Geschäftsführer hat sein Amt weiter auszuüben bis sein Nachfolger gewählt wurde. Jeder Geschäftsführer
kann auch für aufeinander folgende Zeiträume wiedergewählt werden.
Art. 17. Ladung zu Sitzungen des Geschäftsführerrats.
17.1. Der Geschäftsführerrat versammelt sich auf Einberufung durch seinen Präsidenten oder durch zwei (2) seiner
Mitglieder an dem in der Ladung zur Sitzung angegebenen Ort wie im nächsten Abschnitt beschrieben.
17.2. Die Mitglieder des Geschäftsführerrats müssen mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung
anberaumten Datum zu jeder Sitzung des Geschäftsführerrats per Post, Faxschreiben, E-Mail oder durch jedes andere
Kommunikationsmittel schriftlich geladen werden, außer im Notfall, in welchem die Art und die Gründe des Notfalls in
der Ladung zu bezeichnen sind. Eine Ladung ist nicht notwendig im Falle des schriftlichen und unterzeichneten Einver-
ständnisses jedes Mitglieds des Geschäftsführerrats per Post, Faxschreiben, E-Mail oder durch jedes andere Kommuni-
kationsmittel, wobei eine Kopie dieses unterzeichneten schriftlichen Einverständnisses hinreichender Beweis dafür ist.
Auch ist eine Ladung zu Sitzungen des Geschäftsführerrats nicht erforderlich, welche zu einer Zeit und an einem Ort
stattfinden sollen wie in einem vorausgehenden Beschluss des Geschäftsführerrats bestimmt. Eine Ladung soll ferner dann
nicht erforderlich sein, wenn alle Mitglieder des Geschäftsführerrats anwesend oder vertreten sind, oder im Falle von
schriftlichen Umlaufbeschlüssen gemäß diesem Gesellschaftsvertrag.
Art. 18. Verlauf von Sitzungen des Geschäftsführerrats.
18.1. Sitzungen des Geschäftsführerrats werden durch den Präsidenten des Geschäftsführerrats geleitet. In seiner
Abwesenheit kann der Geschäftsführerrat einen anderen Geschäftsführer als vorübergehenden Präsidenten ernennen
18.2. Quorum
Der Geschäftsführerrat kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder
an der Sitzung anwesend oder vertreten ist und, sofern mehrere Klassen von Geschäftsführern ernannt wurden, min-
destens ein (1) Geschäftsführer jeder Klasse anwesend oder vertreten ist.
18.3. Abstimmung
85995
L
U X E M B O U R G
Beschlüsse werden mit der Mehrheit der Stimmen der an einer Sitzung des Geschäftsführerrats anwesenden oder
vertretenen Mitglieder gefasst. Der Präsident soll keine entscheidende Stimme haben.
18.4. Ein Mitglied des Geschäftsführerrats kann an einer Sitzung des Geschäftsführerrats teilnehmen, indem es ein
anderes Mitglied des Geschäftsführerrats schriftlich per Post, Faxschreiben, E-Mail oder durch jedes andere Kommuni-
kationsmittel bevollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung hinreichender Beweis dafür ist. Jedes Mitglied des
Geschäftsführerrats kann einen oder mehrere seiner Kollegen vertreten.
18.5. Es wird vermutet, dass ein Mitglied des Geschäftsführerrats, das an einer Sitzung durch Telefonkonferenz, Vide-
okonferenz oder durch ein anderes Kommunikationsmittel teilnimmt, welches es ermöglicht, dass dieses Mitglied
identifiziert werden kann und dass sich alle Personen, die an der Sitzung teilnehmen, gegenseitig durchgehend hören und
effektiv an der Sitzung teilnehmen können, für die Zusammensetzung von Quorum und Mehrheit anwesend ist. Es wird
vermutet, dass eine durch solche Kommunikationsmittel abgehaltene Sitzung am eingetragenen Sitz der Gesellschaft
abgehalten wurde.
18.6. Der Geschäftsführerrat kann einstimmig schriftliche Beschlüsse fassen, welche dieselbe Wirkung haben wie in
einer ordnungsgemäß geladenen und abgehaltenen Sitzung gefasste Beschlüsse. Solche schriftlichen Beschlüsse sind gefasst,
wenn sie durch alle Mitglieder des Geschäftsführerrats auf einem einzigen Dokument oder auf verschiedenen Duplikaten
datiert und unterzeichnet worden sind, wobei eine Kopie der Unterschrift, die per Post, per Faxschreiben, per E-Mail
oder durch jedes andere Kommunikationsmittel gesendet wurde, hinreichender Beweis dafür ist. Das Dokument, das alle
Unterschriften enthält, oder die Gesamtheit aller Duplikate, je nach Lage des Falles, stellt das Schriftstück dar, welches
das Fassen der Beschlüsse beweist, und das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum solcher Beschlüsse.
18.7. Jeder Geschäftsführer, der an einer Transaktion, die dem Geschäftsführerrat zur Entscheidung vorliegt, direkt
oder indirekt ein vermögensrechtliches Interesse hat, welches mit dem Interesse der Gesellschaft in Konflikt steht, muss
den Geschäftsführerrat über diesen Interessenkonflikt informieren, und seine Erklärung muss im Protokoll der betreff-
enden Sitzung aufgenommen werden. Der betreffende Geschäftsführer kann weder an der Beratung über die in Frage
stehende Transaktion teilnehmen, noch darüber abstimmen. Wenn die Gesellschaft einen einzigen Geschäftsführer hat
und dieser Geschäftsführer in einer zwischen ihm und der Gesellschaft geschlossenen Transaktion direkt oder indirekt
ein vermögensrechtliches Interesse hat, welches mit dem Interesse der Gesellschaft in Konflikt steht, muss dieser Inte-
ressenskonflikt im Protokoll über die betreffende Transaktion aufgenommen werden. Dieser Artikel 18.7 ist nicht
anwendbar auf laufende Geschäfte, die unter normalen Bedingungen geschlossen wurden.
Art. 19. Protokoll von Sitzungen des Geschäftsführerrats.
19.1. Der Sekretär oder, wenn ein solcher nicht ernannt worden ist, der Präsident, soll ein Protokoll über jede Sitzung
des Geschäftsführerrats aufnehmen, welches vom Präsidenten und vom Sekretär, falls vorhanden, unterzeichnet wird.
19.2. Der alleinige Geschäftsführer, soweit anwendbar, soll über seine Beschlüsse ebenfalls ein Protokoll aufnehmen.
19.3. Jede Kopie und jeder Auszug solcher originalen Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren verwendet werden
sollen oder die Dritten zugänglich gemacht werden sollen, sollen, je nach Lage des Falles, vom Präsidenten des Ge-
schäftsführerrats, von zwei beliebigen seiner Mitglieder oder vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet werden.
Art. 20. Geschäfte mit Dritten Die Gesellschaft wird gegenüber. Dritten unter allen Umständen durch die gemeinsame
Unterschrift eines Geschäftsführer der Klasse A und eines Geschäftsführer der Klasse B oder durch die Unterschrift des
alleinigen Geschäftsführers oder durch die gemeinsame Unterschrift oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en)
gebunden, der/denen eine solche Unterschriftsbefugnis durch den Geschäftsführerrat oder den alleinigen Geschäftsführer
übertragen worden ist. Die Gesellschaft wird gemäß den Regeln und in den Grenzen einer Übertragung der Führung des
Tagesgeschäfts gegenüber Dritten durch die Unterschrift jedes/aller Beauftragten gebunden, dem/denen die Befugnis in
Verbindung mit der Führung des Tagesgeschäfts allein oder gemeinschaftlich übertragen wurde.
E. Aufsicht
Art. 21. Satzungsmäßige(r) Buchprüfer - unabhängige(r) Buchprüfer.
21.1. Falls die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden ihre Geschäfte durch einen oder
mehrere satzungsmäßigen Buchprüfer beaufsichtigt, welche Gesellschafter sind oder nicht.
21.2. Die Gesellschafterversammlung soll die Anzahl der satzungsmäßigen Buchprüfer bestimmen, sie ernennen und
ihre Bezahlung und Amtszeit festlegen. Ein ehemaliger oder derzeitiger satzungsmäßiger Buchprüfer kann von der Ge-
sellschafterversammlung wieder ernannt werden.
21.3. Jeder satzungsmäßige Buchprüfer kann jederzeit fristlos und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung
abberufen werden.
21.4. Die satzungsmäßigen Buchprüfer haben ein unbegrenztes Recht stetiger Aufsicht und Kontrolle über alle Ge-
schäfte der Gesellschaft.
21.5. Die satzungsmäßigen Buchprüfer können durch einen Experten unterstützt werden, um die Bücher und Konten
der Gesellschaft zu prüfen. Dieser Experte muss von der Gesellschaft genehmigt sein.
21.6. Im Falle einer Mehrheit satzungsmäßiger Buchprüfer bilden diese einen Rat satzungsmäßiger Buchprüfer, welcher
aus seiner Mitte einen Präsidenten wählen muss. Er kann auch einen Sekretär ernennen, der weder Gesellschafter noch
satzungsmäßiger Buchprüfer sein muss. Betreffend die Ladung zu und das Abhalten von Sitzungen des Rats satzungsmäßiger
85996
L
U X E M B O U R G
Buchprüfer sollen die in diesem Gesellschaftsvertrag genannten Regeln betreffend die Ladung zu und das Abhalten von
Sitzungen des Geschäftsführerrats anwendbar sein.
21.7. Sofern die Gesellschafter einen oder mehrere unabhängige Buchprüfer (réviseur(s) d'entreprises agréé(s)) in
Übereinstimmung mit Artikel 69 des abgeänderten Gesetzes vom 19. Dezember 2002 betreffend das Handelsregister
und die Buchhaltung und den Jahresabschluss von Unternehmen bestimmen, so ersetzt/ersetzen dieser/diese unabhängige
(n) Buchprüfer den/die satzungsmäßige(n) Buchprüfer.
F. Geschäftsjahr - Gewinne - Zwischendividenden
Art. 22. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar jedes Jahres und endet am ein-
unddreißigsten Dezember desselben Jahres.
Art. 23. Gewinne.
23.1. Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage
der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung soll dann nicht mehr verpflichtend sein, sobald und so lange die Gesamt-
summe der Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Kapitals der Gesellschaft beträgt.
23.2. Die durch einen Gesellschafter an die Gesellschaft erbrachten Einlagen können ebenfalls der gesetzlichen Rücklage
zugeführt werden, wenn der einlegende Gesellschafter dieser Zuführung zustimmt.
23.3. Im Falle einer Herabsetzung des Kapitals kann die gesetzliche Rücklage der Gesellschaft im Verhältnis herabgesetzt
werden, so dass sie zehn Prozent (10%) des Kapitals nicht übersteigt.
23.4. Unter den gesetzlichen Bedingungen und auf Empfehlung durch den Geschäftsführerrat wird die Gesellschafter-
versammlung beschließen, wie der verbleibende Rest des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft gemäß dem Gesetz
und diesem Gesellschaftsvertrag verwendet werden soll.
Art. 24. Zwischendividenden - Emissionsagio.
24.1. Der Geschäftsführerrat oder die Gesellschafterversammlung kann Zwischendividenden zahlen unter der Vo-
raussetzung, dass (i) Zwischenkonten erstellt wurden, nach denen genügend Mittel verfügbar sind, (ii) der auszuschüttende
Betrag nicht die Gesamtsumme der Gewinne übersteigt, die seit Abschluss des letzten Geschäftsjahres, für welches der
Jahresabschluss genehmigt wurde, realisiert worden sind, einschließlich vorgetragener Gewinne und Summen, die aus zu
diesem Zweck verfügbaren Rücklagen entnommen wurden, abzüglich vorgetragener Verluste und solcher Summen, die
gemäß dem Gesetz oder diesem Gesellschaftsvertrag der Reserve zuzuführen sind, und (iii) der Buchprüfer der Gesell-
schaft, falls vorhanden, in seinem Bericht an den Geschäftsführerrat erklärt, dass die beiden erstgenannten Bedingungen
erfüllt sind.
24.2. Das Emissionsagio, falls vorhanden, kann durch Gesellschafterbeschluss oder Beschluss der Geschäftsführer unter
Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen betreffend die Unantastbarkeit des Kapitals und die gesetzliche Rücklage frei
an den/die Gesellschafter ausgeschüttet werden.
G. Liquidation
Art. 25. Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquida-
toren, natürliche oder juristische Personen, ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, die
die Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Bezahlung der Liquidatoren bestimmt.
H. Anwendbares recht
Art. 26. Anwendbares Recht. Der Gesellschaftsvertrag und seine Auslegung und Interpretation unterliegen Luxem-
burger Recht. Alle in diesem Gesellschaftsvertrag nicht geregelten Angelegenheiten sollen gemäß dem Gesetz vom 10.
August 1915 über Handelsgesellschaften in der geänderten Fassung bestimmt werden.
<i>Übergangsbestimmungeni>
1) Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember
2014.
2) Zwischendividenden können auch während des ersten Geschäftsjahres der Gesellschaft ausgeschüttet werden.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Der zeichnende Gesellschafter hat die auszugebenden Geschäftsanteile wie folgt gezeichnet:
1) OEC Holdings 4 LP, vorbenannt,
zahlte zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) gegen Zeichnung von zwölftausendfünfhundert (12.500) Ge-
schäftsanteilen.
Gesamt: zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) gezahlt für zwölftausendfünfhundert (12.500) Geschäftsanteile.
Alle Geschäftsanteile sind ganz in bar eingezahlt worden, so dass die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR
12.500,-) von jetzt an der Gesellschaft zur Verfügung steht wie es dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.
85997
L
U X E M B O U R G
<i>Auslageni>
Die Auslagen, Kosten, Vergütungen oder Belastungen welcher Art auch immer, die der Gesellschaft im Zusammenhang
mit ihrer Gründung entstanden sind oder die von der Gesellschaft im Zusammenhang mit ihrer Gründung getragen werden
sollen, werden auf EUR 1.500,- geschätzt.
<i>Beschlüsse des alleingesellschaftersi>
Der Gründungsgesellschafter, welche das gesamte Kapital der Gesellschaft repräsentiert, hat sofort die folgenden
Beschlüsse gefasst.
1) Die Zahl der Mitglieder des Geschäftsführerrats wird auf vier (4) festgesetzt.
2) Die folgenden Personen werden als Mitglieder des Geschäftsführerrats der Gesellschaft ernannt:
a) Frau Allison Steiner, geboren am 6 Mai 1972 in Corpus Christi, Texas, USA, mit beruflicher Adresse c/o Rhône
Group LLC, 630 Fifth Avenue, New York, NY 10111, Vereinigte Staaten von Amerika, Klasse A Geschäftsführerin;
b) Herr Lucas Flynn, geboren am 20 Dezember 1978 in La Plata, Argentinien, mit beruflicher Adresse in 40 Bruton
Street, London, W1J6QZ, United Kingdom, Klasse A Geschäftsführer;
c) Frau Virginia Jennifer Strelen, geboren am 30 Mai 1977 in Bergisch Gladbach, Deutschland, mit beruflicher Adresse
in 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, Klasse B Geschäftsführerin; und
d) Herr Wim José August Rits, geboren am 14 Juni 1970 in Merksem, Belgien, mit beruflicher Adresse in 15, rue Edward
Steichen, L-2540 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, Klasse B Geschäftsführer.
Die Amtszeit der Mitglieder des Geschäftsführerrats soll zu dem Zeitpunkt enden, an dem die Gesellschafterver-
sammlung/der alleinige Gesellschafter, je nach Lage des Falles, über die Genehmigung des Jahresabschlusses der Gesell-
schaft für das Geschäftsjahr 2014 bestimmt, oder an jedem anderen, von der Gesellschafterversammlung/vom alleinigen
Gesellschafter, je nach Lage des Falles, festgesetzten Zeitpunkt vor diesem Datum.
3) Die Anschrift des Gesellschaftssitzes ist 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
Der unterzeichnete Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die Urkunde auf Anfrage der er-
schienenen Partei auf Englisch geschrieben ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Auf Anfrage derselben erschie-
nenen Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text soll die englische Fassung
vorrangig sein.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, an dem am Anfang dieses Dokuments
genannten Tag.
Nachdem das Dokument dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei vorgelesen worden ist, hat der Bevollmäch-
tigte diese originale Urkunde zusammen mit dem Notar unterzeichnet.
Gezeichnet: S. JOLY-MEUNIER und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 30 avril 2014. Relation: LAC/2014/20150. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - Der Gesellschaft auf Begehr erteilt.
Luxemburg, den 8. Mai 2014.
Référence de publication: 2014065532/758.
(140076657) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2014.
Nylda, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 170.826.
EXTRAIT
Les associés, dans leurs résolutions du 30 avril 2014, ont renouvelé les mandats des gérants.
- Monsieur Richard HAWEL, directeur de sociétés, 8, rue Yolande, L-2761 Luxembourg, gérant de catégorie B.
- Monsieur Nyls VOURIOT, cadre commercial, 75, rue Alfred Roll, F-77590 Bois le Roi, France, gérant de catégorie
A.
Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2013.
Luxembourg, le 30 avril 2014.
<i>Pour NYLDA
i>Société à responsabilité limitée
Référence de publication: 2014065190/17.
(140076172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2014.
85998
L
U X E M B O U R G
BRE/Munich IV Manager S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 96.606.
Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014064003/9.
(140074385) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2014.
CMB Global Lux, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 55.178.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour CMB Global Lux
i>CACEIS Bank Luxembourg
Référence de publication: 2014064076/11.
(140074822) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2014.
WSHP GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 186.813.
STATUTES
In the year two thousand and fourteen, on the twenty-ninth of the month of April.
Before us Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
WSHP Orgentec Holdco, LLC, a limited liability company incorporated and existing under the laws of the State of
Delaware, United States of America, registered with the Division of Corporations of the State of Delaware under number
5518111, with registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801, United States of America,
here represented by Me Michael Jonas, lawyer, professionally residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given in Chicago, Illinois on 21 April 2014.
The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed
to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party has requested the officiating notary to enact the deed of incorporation of a private limited
company (société à responsabilité limitée) which it wishes to incorporate with the following articles of association:
A. Name - Purpose - Duration - Registered office
Art. 1. Name - Legal Form. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name
WSHP GP Sàrl (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial
companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.
Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign
companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio.
2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it
holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the
Company.
2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by
issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.
2.4 The Company may also act as a partner/shareholder with unlimited or limited liability for the debts and obligations
of any Luxembourg or foreign entity.
2.5 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities
which it considers useful for the accomplishment of these purposes.
85999
L
U X E M B O U R G
Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of
managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution
of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution
of the board of managers.
4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances
or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
traordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwiths-
tanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.
B. Share capital - Shares
Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), represented by twelve
thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one (EUR 1) each.
5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
5.3 The Company may redeem its own shares.
Art. 6. Shares.
6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of
the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.
Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection
by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.
7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall
appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.
7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given
by the shareholders at a majority of three quarters of the share capital.
7.5 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of
the transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.
7.6 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject
to the approval of such transfer given by the surviving shareholders at a majority of three quarters of the share capital.
Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving
spouse.
C. Decisions of the shareholders
Art. 8. Collective decisions of the shareholders.
8.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles
of association.
8.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
8.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise
conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case,
each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his
vote in writing.
86000
L
U X E M B O U R G
8.4 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of
shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by
the sole shareholder.
Art. 9. General meetings of shareholders. Meetings of shareholders may be held at such place and time as may be
specified in the respective convening notices of meeting. If all of the shareholders are present or represented at a general
meeting of shareholders and have waived any convening requirement, the meeting may be held without prior notice or
publication.
Art. 10. Quorum and vote.
10.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
10.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company's
shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share
capital.
Art. 11. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.
Art. 12. Amendments of the articles of association. Any amendment of the articles of association requires the approval
of (i) a majority of shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.
D. Management
Art. 13. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
13.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers
form a board of managers, which shall include at least one (1) class A manager and one (1) class B manager.
13.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not
expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of
association is to be construed as a reference to the “sole manager”.
13.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any
actions necessary or useful to fulfil the Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the
Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.
Art. 14. Appointment, removal and term of office of managers.
14.1 The manager(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remune-
ration and term of office.
14.2 The managers shall be appointed and may be removed from office at any time, with or without cause, by a decision
of the shareholders representing more than half of the Company's share capital.
Art. 15. Vacancy in the office of a manager.
15.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or
otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the replaced manager by the remaining managers until the next meeting of shareholders which shall resolve on the
permanent appointment, in compliance with the applicable legal provisions.
15.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company's sole manager, such vacancy must be filled without undue
delay by the general meeting of shareholders.
Art. 16. Convening meetings of the board of managers.
16.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held
at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.
16.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four (24) hours at
least in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document
being sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location
determined in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.
16.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive
any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of
managers.
Art. 17. Conduct of meetings of the board of managers.
17.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not
need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
86001
L
U X E M B O U R G
17.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any
such meeting.
17.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either
in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.
17.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other
means of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis
and allowing an effective participation in the meeting. Participation in a meeting by these means is equivalent to partici-
pation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.
17.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or
represented at a meeting of the board of managers.
17.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,
if any, shall not have a casting vote.
17.7. The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in
writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be
the date of the last signature.
Art. 18. Minutes of the meeting of the board of managers. Minutes of the decisions of the sole manager
18.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by
the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. Copies or excerpts of such minutes,
which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if any, or by any two (2)
managers.
18.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.
Art. 19. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the
signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of a class A manager and
a class B manager, or (ii) by the joint signatures or the sole signature of any person(s) to whom such signatory power
may have been delegated by the board of managers within the limits of such delegation.
E. Audit and supervision
Art. 20. Auditor(s).
20.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company
shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.
20.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting
of shareholders.
20.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
20.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d'entreprises agréé
(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies register and the
accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.
20.5. An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its
approval.
F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends
Art. 21. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end
on the thirty-first of December of the same year.
Art. 22. Annual accounts and allocation of profits.
22.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of
the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.
22.2. Of the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve. This
allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten per
cent (10%) of the share capital of the Company.
22.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the
contributing shareholder agrees to such allocation.
22.4 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does
not exceed ten per cent (10%) of the share capital.
86002
L
U X E M B O U R G
22.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the
remainder of the Company's profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.
Art. 23. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
23.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared
by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may
not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable
reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles
of association do not allow to be distributed.
23.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the share-
holders subject to the provisions of the Law and these articles of association.
G. Liquidation
Art. 24. Liquidation. In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of
association, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting
of shareholders deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless other-
wise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the
liabilities of the Company.
H. Final clause - governing law
Art. 25. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance
with the Law.
<i>Transitional provisionsi>
1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 31 December
2014.
2. Interim dividends may be distributed during the Company's first financial year.
<i>Subscription and paymenti>
The twelve thousand five hundred (12,500) shares issued have been subscribed by WSHP Orgentec Holdco, LLC
aforementioned, for the price of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500).
The shares so subscribed have been fully paid up by a contribution in cash so that the amount of twelve thousand five
hundred euro (EUR 12,500) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
The total contribution in the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) is entirely allocated to the
share capital.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be
borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately one thousand four hundred
euro (EUR 1,400).
<i>Resolutions of the shareholderi>
The incorporating shareholder, representing the entire share capital of the Company and having waived any convening
requirements, has passed the following resolutions:
1. The address of the registered office of the Company is set at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
2. The following persons are appointed as managers of the Company for an unlimited term:
(i) Mrs Frédérique Duculot, born in Liège, Belgium on 7 May 1978, professionally residing at 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg as class A manager of the Company; and
(ii) Mr Philippe Leclercq, born in Liège, Belgium on 18 May 1968, professionally residing at 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg as class B manager of the Company.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-
ment.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxyholder of
the appearing party, this deed is worded in English followed by a French translation; at the request of the same proxyholder
and in case of divergence between the English and the French text, the English version shall prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name
and residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française de ce qui précède.
L'an deux mille quatorze, le vingt-neuf du mois d'avril.
86003
L
U X E M B O U R G
Par devant nous Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorfles-Bains, Grand-duché de Luxembourg.
A COMPARU:
WSHP Orgentec Holdco, LLC, une limited liability company constituée et existante selon les lois de l'Etat du Delaware,
Etats-Unis d'Amérique, immatriculée au Division of Corporations de l'Etat du Delaware sous le numéro 5518111, ayant
son siège social à 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801, Etats-Unis d'Amérique,
dûment représentée par Maître Michael Jonas, avocat, résidant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Chicago, Illinois, le 21 avril 2014.
Ladite procuration, paraphée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire, restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.
La comparante a requis le notaire instrumentant de dresser l'acte de constitution d'une société à responsabilité limitée
qu'il souhaite constituer avec les statuts suivants:
A. Nom - Objet - Durée - Siège social
Art. 1
er
. Nom - Forme. Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination “WSHP GP Sàrl” (ci-après
la “Société”) qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la “Loi”),
ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. Objet.
2.1 La Société a pour objet la détention de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-
bourgeoises et étrangères et de toute autre forme de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, de même que le transfert par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de tout type, ainsi
que l'administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de son portefeuille de participations.
2.2 La Société peut également garantir, accorder des sûretés, accorder des prêts ou assister de toute autre manière
des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou un droit de quelque nature que ce soit
ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.
2.3 Excepté par voie d'appel publique à l'épargne, la Société peut lever des fonds en faisant des emprunts sous toute
forme ou en émettant toute sorte d'obligations, de titres ou d'instruments de dettes, d'obligations garanties ou non
garanties, et d'une manière générale en émettant des valeurs mobilières de tout type.
2.4 La Société a également la possibilité d'agir en tant qu'associé ou actionnaire à responsabilité illimitée ou limitée
pour les dettes et les obligations de n'importe quelle entité luxembourgeoise ou étrangère.
2.5 La Société peut exercer toute activité de nature commerciale, industrielle, financière, immobilière ou de propriété
intellectuelle qu'elle estime utile pour l'accomplissement de ces objets.
Art. 3. Durée.
3.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
3.2 Elle peut être dissoute à tout moment et sans cause par une décision de l'assemblée générale des associés, adoptée
selon les conditions requises pour une modification des présents statuts.
Art. 4. Siège social.
4.1 Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
4.2 Le siège social peut être transféré au sein de la même commune par décision du conseil de gérance. Il peut être
transféré dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée générale des associés,
adoptée selon les conditions requises pour une modification des présents statuts.
4.3 Des succursales ou bureaux peuvent être créés, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, par décision
du conseil de gérance.
4.4 Dans l'hypothèse où le conseil de gérance estimerait que des événements exceptionnels d'ordre politique, éco-
nomique ou social ou des catastrophes naturelles se sont produits ou seraient imminents, de nature à interférer avec
l'activité normale de la Société à son siège social, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à
la cessation complète de ces circonstances exceptionnelles; ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur
la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.
B. Capital social - Parts sociales
Art. 5. Capital social.
5.1 Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par douze mille cinq
cents (12.500) parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune.
5.2 Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une décision de l'assemblée générale des associés
de la Société, adoptée selon les modalités requises pour la modification des présents statuts.
5.3 La Société peut racheter ses propres parts sociales.
86004
L
U X E M B O U R G
Art. 6. Parts sociales.
6.1 Le capital social de la Société est divisé en parts sociales ayant chacune la même valeur nominale.
6.2 Les parts sociales de la Société sont nominatives.
6.3 La Société peut avoir un ou plusieurs associés, avec un nombre maximal de quarante (40) associés.
6.4 Le décès, la suspension des droits civils, la dissolution, la liquidation, la faillite ou l'insolvabilité ou tout autre
événement similaire d'un des associés n'entraînera pas la dissolution de la Société.
Art. 7. Registre des parts sociales - Transfert des parts sociales.
7.1 Un registre des parts sociales est tenu au siège social de la Société où il est mis à disposition de chaque associé
pour consultation. Ce registre contient toutes les informations requises par la Loi. Des certificats d'inscription peuvent
être émis sur demande et aux frais de l'associé demandeur.
7.2 La Société ne reconnaît qu'un seul titulaire par part sociale. Les copropriétaires indivis nommeront un représentant
unique qui les représentera vis-à-vis de la Société. La Société a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits relatifs
à cette part sociale, jusqu'à ce qu'un tel représentant ait été désigné.
7.3 Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
7.4 Inter vivos, les parts sociales seront uniquement transférables à de nouveaux associés sous réserve qu'une telle
cession ait été approuvée par les associés représentant une majorité des trois quarts du capital social.
7.5 Toute cession de parts sociales est opposable à la Société et aux tiers sur notification de la cession à, ou après
l'acceptation de la cession par la Société conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil.
7.6 En cas de décès, les parts sociales de l'associé décédé pourront être uniquement transférées au nouvel associé
sous réserve qu'un tel transfert ait été approuvé par les associés survivants à une majorité des trois quarts du capital
social. Un tel agrément n'est cependant pas requis dans l'hypothèse où les parts sociales sont transférées soit aux as-
cendants, descendants ou au conjoint survivant.
C. Décisions des associés
Art. 8. Décisions collectives des associés.
8.1 L'assemblée générale des associés est investie des pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la Loi et par
les présents statuts.
8.2 Chaque associé a la possibilité de participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts sociales qu'il
détient.
8.3 Dans l'hypothèse où et tant que la Société n'a pas plus de vingt-cinq (25) associés, des décisions collectives qui
relèveraient d'ordinaire de la compétence de l'assemblée générale, pourront être valablement adoptées par voie de
décisions écrites. Dans une telle hypothèse, chaque associé recevra le texte de ces résolutions ou des décisions à adopter
expressément formulées et votera par écrit.
8.4 En cas d'associé unique, cet associé exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés en vertu des
dispositions de la section XII de la Loi et des présents statuts. Dans cette hypothèse, toute référence faite à “l'assemblée
générale des associés” devra être entendue comme une référence à l'associé unique selon le contexte et le cas échéant
et les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés seront exercés par l'associé unique.
Art. 9. Assemblées générales des associés. Les assemblées générales d'associés pourront être tenues aux lieux et
heures indiquées dans les convocations aux assemblées générales correspondantes. Si tous les associés sont présents ou
représentés à l'assemblée générale des associés et renoncent aux formalités de convocation, l'assemblée pourra être
tenue sans convocation ou publication préalable.
Art. 10. Quorum et vote.
10.1 Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il détient.
10.2 Sous réserve d'un quorum plus élevé prévu par les présents statuts ou la Loi, les décisions collectives des associés
de la Société ne seront valablement adoptées que pour autant qu'elles auront été adoptées par des associés détenant
plus de la moitié du capital social.
Art. 11. Changement de nationalité. Les associés ne peuvent changer la nationalité de la Société qu'avec le consente-
ment unanime des associés.
Art. 12. Modification des statuts. Toute modification des statuts requiert l'accord d'une (i) majorité des associés (ii)
représentant au moins les trois quarts du capital social.
D. Gérance
Art. 13. Pouvoirs du gérant unique - Composition et pouvoirs du conseil de gérance.
13.1 La Société peut être gérée par un ou plusieurs gérants. Si la Société a plusieurs gérants, les gérants forment un
conseil de gérance, qui sera composé d'au moins un (1) gérant de catégorie A et d'un (1) gérant de catégorie B.
86005
L
U X E M B O U R G
13.2 Lorsque la Société est gérée par un gérant unique, le cas échéant et lorsque le terme “gérant unique” n'est pas
expressément mentionné dans ces statuts, une référence au “conseil de gérance” dans ces statuts devra être entendue
comme une référence au “gérant unique”.
13.3 Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société et pour prendre
toute mesure nécessaire ou utile pour l'accomplissement de l'objet social de la Société, à l'exception des pouvoirs réservés
par la Loi ou par les présents statuts à l'assemblée générale des associés.
Art. 14. Nomination, révocation des gérants et durée du mandat des gérants.
14.1 Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) par l'assemblée générale des associés qui détermine sa (leur) rémunération
et la durée de son (leur) mandat.
14.2 Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) et peu(ven)t être librement révoqué(s) à tout moment, avec ou sans motif,
par une décision des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.
Art. 15. Vacance d'un poste de gérant.
15.1 Dans l'hypothèse où un poste de gérant deviendrait vacant suite au décès, à l'incapacité juridique, la faillite, la
démission ou pour tout autre motif, cette vacance peut être pourvue de manière temporaire et pour une période ne
pouvant excéder celle du mandat initial du gérant remplacé par les gérants restants jusqu'à la prochaine assemblée des
associés appelée à statuer sur la nomination permanente, conformément aux dispositions légales applicables.
15.2 Dans l'hypothèse où la vacance survient alors que la Société est gérée par un gérant unique, cette vacance est
comblée sans délai par l'assemblée générale des associés.
Art. 16. Convocation aux réunions du conseil de gérance.
16.1 Le conseil de gérance se réunit sur convocation de tout gérant. Les réunions du conseil de gérance sont tenues
au siège social de la Société sauf indication contraire dans la convocation à la réunion.
16.2 Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance doit être donné aux gérants au minimum vingt-quatre (24)
heures à l'avance par rapport à l'heure fixée dans la convocation, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les motifs
d'une telle urgence seront mentionnées dans la convocation. Une telle convocation peut être omise en cas d'accord écrit
de chaque gérant, par télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Une copie d'un tel
document signé constituera une preuve suffisante d'un tel accord. Aucune convocation préalable ne sera exigée pour un
conseil de gérance dont le lieu et l'heure auront été déterminés par une décision adoptée lors d'un précédent conseil de
gérance, communiquée à tous les membres du conseil de gérance.
16.3 Aucune convocation préalable ne sera requise dans l'hypothèse où tous les gérants seront présents ou représentés
à un conseil de gérance et renonceraient aux formalités de convocation ou dans l'hypothèse de décisions écrites et
approuvées par tous les membres du conseil de gérance.
Art. 17. Conduite des réunions du conseil de gérance.
17.1 Le conseil de gérance peut élire un président du conseil de gérance parmi ses membres. Il peut également désigner
un secrétaire, qui peut ne pas être membre du conseil de gérance et qui sera chargé de tenir les procès-verbaux des
réunions du conseil de gérance.
17.2 Le président du conseil de gérance, le cas échéant, préside toutes les réunions du conseil de gérance. En son
absence, le conseil de gérance peut nommer provisoirement un autre gérant comme président temporaire par un vote
à la majorité des voix présentes ou représentées à la réunion.
17.3 Tout gérant peut se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant tout autre gérant comme
son mandataire par écrit, ou par télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, une copie du
mandat en constituant une preuve suffisante. Un gérant peut représenter un ou plusieurs, mais non l'intégralité des
membres du conseil de gérance.
17.4 Les réunions du conseil de gérance peuvent également se tenir par téléconférence ou vidéoconférence ou par
tout autre moyen de communication similaire permettant à toutes les personnes y participant de s'entendre mutuellement
sans discontinuité et garantissant une participation effective à cette réunion. La participation à une réunion par ces moyens
équivaut à une participation en personne et la réunion tenue par de tels moyens de communication est réputée s'être
tenue au siège social de la Société.
17.5 Le conseil de gérance ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité de ses membres est
présente ou représentée à une réunion du conseil de gérance.
17.6 Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à chaque réunion du conseil
de gérance. Le président du conseil de gérance, le cas échéant, ne dispose pas d'une voix prépondérante.
17.7 Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, prendre des décisions par voie circulaire en exprimant son approbation
par écrit, par télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Chaque gérant peut exprimer
son consentement séparément, l'ensemble des consentements attestant de l'adoption des décisions. La date de ces dé-
cisions sera la date de la dernière signature.
86006
L
U X E M B O U R G
Art. 18. Procès-verbaux des réunions du conseil de gérance Procès-verbaux des décisions du gérant unique.
18.1 Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président, le cas échéant,
ou, en son absence, par le président temporaire, et le secrétaire, le cas échéant, ou par deux (2) gérants. Les copies ou
extraits de ces procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou autre seront, le cas échéant, signés par le président
ou par deux (2) gérants.
18.2 Les décisions du gérant unique sont retranscrites dans des procès-verbaux qui seront signés par le gérant unique.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou dans tout autre contexte seront
signés par le gérant unique.
Art. 19. Rapports avec les tiers. La Société sera valablement engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances (i) par
la signature du gérant unique, ou, si la Société a plusieurs gérants, par la signature conjointe d'un gérant de catégorie A
et d'un gérant de catégorie B, ou (ii) par la signature conjointe ou la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle/
auxquelles pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil de gérance, dans les limites de cette délégation.
E. Audit et surveillance
Art. 20. Commissaire(s) - Réviseur(s) d'entreprises agréé(s).
20.1 Dans l'hypothèse où, et tant que la Société aura plus de vingt-cinq (25) associés, les opérations de la Société
seront surveillées par un ou plusieurs commissaires. L'assemblée générale des associés désigne les commissaires et dé-
termine la durée de leurs fonctions.
20.2 Un commissaire pourra être révoqué à tout moment, sans préavis et sans motif, par l'assemblée générale des
associés.
20.3 Le commissaire a un droit illimité de surveillance et de contrôle permanents sur toutes les opérations de la Société.
20.4 Si les associés de la Société désignent un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés conformément à l'article 69
de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes
annuels des entreprises, telle que modifiée, la fonction de commissaire sera supprimée.
20.5 Le réviseur d'entreprises agréé ne pourra être révoqué par l'assemblée générale des associés que pour juste motif
ou avec son accord.
F. Exercice social - Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Acomptes Sur dividendes
Art. 21. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine
le trente et un décembre de la même année.
Art. 22. Comptes annuels - Distribution des bénéfices.
22.1 Au terme de chaque exercice social, les comptes sont clôturés et le conseil de gérance dresse un inventaire de
l'actif et du passif de la Société, le bilan et le compte de profits et pertes, conformément à la loi.
22.2 Sur les bénéfices annuels nets de la Société, cinq pour cent (5%) au moins seront affectés à la réserve légale. Cette
affectation cessera d'être obligatoire dès que et tant que le montant total de la réserve légale de la Société atteindra dix
pour cent (10%) du capital social de la Société.
22.3 Les sommes apportées à une réserve de la Société par un associé peuvent également être affectées à la réserve
légale, si cet associé consent à cette affectation.
22.4 En cas de réduction du capital social, la réserve légale de la Société pourra être réduite en proportion afin qu'elle
n'excède pas dix pour cent (10%) du capital social.
22.5 Sur proposition du conseil de gérance, l'assemblée générale des associés décide de l'affectation du solde des
bénéfices distribuables de la Société conformément à la Loi et aux présents statuts.
Art. 23. Acomptes sur dividendes - Prime d'émission et primes assimilées.
23.1 Le conseil de gérance peut décider de distribuer des acomptes sur dividendes sur la base d'un état comptable
intermédiaire préparé par le conseil de gérance et faisant apparaître que des fonds suffisants sont disponibles pour être
distribués. Le montant destiné à être distribué ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice
social, augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes
destinées à être affectées à une réserve dont la Loi ou les présents statuts interdisent la distribution.
23.2 Toute prime d'émission, prime assimilée ou réserve distribuable peut être librement distribuée aux associés
conformément à la Loi et aux présents statuts.
G. Liquidation
Art. 24. Liquidation.
24.1 En cas de dissolution de la Société conformément à l'article 3.2 des présents statuts, la liquidation sera effectuée
par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale des associés ayant décidé de cette dissolution et qui
fixera les pouvoirs et émoluments de chacun des liquidateurs. Sauf disposition contraire, les liquidateurs disposeront des
pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et du passif de la Société.
86007
L
U X E M B O U R G
H. Disposition finale - loi applicable
Art. 25. Loi applicable. Tout ce qui n'est pas régi par les présents statuts, sera déterminé en conformité avec la Loi.
<i>Dispositions transitoiresi>
1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2014.
2. Des acomptes sur dividendes pourront être distribués pendant le premier exercice social de la Société.
<i>Souscription et paiementi>
Les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales émises ont été souscrites par WSHP Orgentec Holdco, LLC, sus-
mentionné, pour un prix de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500).
Toutes les parts sociales ainsi souscrites ont été intégralement libérées par voie d'apport en numéraire, de sorte que
le montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) est dès à présent à la disposition de la Société, ce dont il a été
justifié au notaire soussigné.
L'apport global d'un montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) est entièrement affecté au capital social.
<i>Fraisi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué à environ mille quatre cents euros (EUR 1.400).
<i>Résolutions des associési>
L'associé fondateur, représentant l'intégralité du capital social de la Société et ayant renoncé aux formalités de con-
vocation, a adopté les résolutions suivantes:
1. L'adresse du siège social de la Société est établie au 5 rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
2. Les personnes suivantes sont nommées gérants pour une durée illimitée:
(i) Mme Frédérique Duculot, né à Liège, Belgique, le 7 mai 1978, résidant professionnellement à 5 rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, en qualité de gérant de catégorie A; de la Société; et
(ii) M Philippe Leclercq, né à Liège, Belgique, le 18 mai 1968, résidant professionnellement à 5 rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, en qualité de gérant de catégorie B de la Société.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate sur demande du mandataire de la comparante que le
présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français; à la demande du même mandataire et en cas
de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
L'acte ayant été lu au mandataire de la comparante connu du notaire instrumentant par nom, prénom, et résidence,
ledit mandataire de la comparante a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Jonas, M. Loesch.
Enregistré à Remich, le 5 mai 2014. REM/2014/1000. Reçu soixante-quinze euros.75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
Pour expédition conforme,
Mondorf-les-Bains, le 9 mai 2014.
Référence de publication: 2014065398/503.
(140076272) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2014.
Simran Mediatech S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.
R.C.S. Luxembourg B 119.591.
<i>Extrait des résolutions circulaires du conseil d'administration prises en date du 24 février 2014i>
Les membres du Conseil d'administration décident de transférer le siège social de la Société de L-1330 Luxembourg,
34A, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, à L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach, avec effet au 1
er
mars
2014.
Ils prennent note qu'à partir du 1
er
mars 2014, la nouvelle adresse professionnelle de Monsieur François Georges,
administrateur de la Société, sera la suivante: 127, rue de Mühlenbach, L-2168 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
SIMRAN MEDIATECH S.A.
Référence de publication: 2014064508/14.
(140074838) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2014.
86008
L
U X E M B O U R G
Technical Concepts Luxembourg, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 114.126.
In the year two thousand fourteen, on the thirty-first of March;
Before Us Me Henri Hellinckx, notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned;
THERE APPEARED:
SANFORD ROTRING (GB) LIMITED, a private company limited by shares incorporated and existing under the laws
of England and Wales, with registered office at Halifax Avenue, Fradley Park, Lichfield, Staffordshire WS13 8SS, United
Kingdom, registered with Companies House under number 1011290,
here represented by Eugène Tchen, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal; such proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy-holder
and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.
This appearing party, represented as said before, has declared and requested the officiating notary to state:
- That the private limited liability company "Technical Concepts Luxembourg S.à r.l.", a private limited liability company
(société à responsabilité limitée), established and existing under the law of the Grand Duchy of Luxembourg, having its
registered office at 412F, route d’Esch, L-1030 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’
Register, Section B, under the number 114.126, having a share capital of EUR 12,500 (the "Company"), has been incor-
porated by deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 28 December
2005, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 897 of 8 May 2006, and that the articles
of association have not been amended since.
- That the appearing party is the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of the Company and that it has taken,
through its proxy-holder, the following resolutions:
<i>First Resolutioni>
The Sole Shareholder decides to amend the provisions of the articles of association of the Company in order to remove
the requirement of having classes of managers in the event that the Company has several managers and the related
signatory requirements.
<i>Second Resolutioni>
The Sole Shareholder decides to amend subsequently article 12 of the articles of association of the Company which
shall now read as follows:
Art. 12. The Company is managed by one or several managers, which do not need to be shareholders. In dealings with
third parties, the manager(s) has (have) the most extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to authorise all transactions consistent with the Company’s object. The manager(s) is (are) appointed by the general
meeting of shareholders which sets the term of their office. The manager(s) may be dismissed freely at any time, without
there having to exist any legitimate reason («cause légitime»).
In the case of several managers, the Company is managed by a board of managers.
The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one,
by the sole signature of any manager or the signature of any person to whom such signatory power shall be delegated by
the sole manager/board of managers.
The sole manager or the board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by
private instrument.
<i>Third Resolutioni>
The Sole Shareholder decide to acknowledge the resignation of (i) Mr. Smaïn Bouchareb and (ii) Ms. Candice De Boni,
both with professional address at 412 F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, from their mandate as Class B Managers of
the Company with effect as of 1 January 2014.
The Sole Shareholder decides to reduce the number of members of the board of managers from three (3) to two (2)
with immediate effect.
The Sole Shareholder further decides to appoint Mr. Richard Hyam, born the 25
th
March 1963 in Hillingdon, United
Kigndom, with professional address at 10, Chemin de Blandonnet, 1214 Vernier, Switzerland, as manager of the Company
for an unlimited period of time and with immediate effect.
As a consequence of the above resolutions, the board of managers of the Company is now composed as follows:
- Mr. Michael Richard Peterson, manager.
- Mr. Richard Hyam, manager.
86009
L
U X E M B O U R G
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand four hundred Euros
(1.400.- EUR).
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above
appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
party, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the proxy-holder of the appearing party, acting as said before, known to the notary
by name, first name, civil status and residence, the said proxy-holder has signed with Us the notary the present deed.
Suit la version en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille quatorze, le trente-et-un mars;
Pardevant Nous Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné;
A COMPARU:
SANFORD ROTRING (GB) LIMITED, une société à responsabilité limitée (private company limited by shares) con-
stituée et établie selon les lois de l'Angleterre et du Pays de Galles, ayant son siège social à Halifax Avenue, Fradley Park,
Lichfield, Staffordshire WS13 8SS, Royaume-Uni, immatriculée auprès du Companies House sous le numéro 1011290,
ici représenté par Eugène Tchen, demeurant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée; laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par
le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.
Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:
- Que la société à responsabilité limitée "Technical Concepts Luxembourg S.à r.l.", ayant son siège social à 412F, route
d’Esch, L-1030 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro
114.126, a été constituée suivant acte reçu du notaire Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en
date du 28 décembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 897 du 8 mai 2006, et
dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis;
- Que le comparant est le seul associé (l'"Associé Unique") de la Société et qu'il a pris, par son mandataire, les réso-
lutions suivantes:
<i>Première Résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier les dispositions des statuts de la Société en rapport avec le nombre des gérants
de la Société afin d'annuler la nécessité d'avoir des gérants de classes différentes lorsque la Société a plusieurs gérants
ainsi que les pouvoirs de signature relatives.
<i>Deuxième Résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier en conséquence l'article 12 des statuts de la Société qui se lira désormais comme
suit:
" Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n’ont pas besoin d’être associés. Vis-à-vis des tiers, le
conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire
autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par l'assemblée générale des
associés laquelle fixera la durée de leur mandat. Les gérants sont librement et à tout moment révocables, sans qu’il soit
nécessaire qu’une cause légitime existe.
En cas de pluralité de gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance.
La Société est engagée en toutes circonstances par la signature du gérant unique ou, lorsqu’il y a plusieurs gérants, par
la signature unique de tout gérant, ou la seule signature de toute personne à laquelle pareils pouvoirs de signature auront
été délégués par le gérant unique / conseil de gérance.
Le gérant unique / conseil de gérance peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou
sous seing privé."
<i>Troisième Résolutioni>
L'Associé unique prend connaissance de la démission de (i) Monsieur Smaïn Bouchareb et (ii) Madame Candice De
Boni, tous deux ayant leur adresse professionnelle au 412 F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, de leur mandat de Gérant
de Classe B de la Société avec effet au 1 janvier 2014.
L'Associé Unique décide de réduire le nombre des membres du conseil de gérance de trois (3) à deux (2) avec effet
immédiat.
86010
L
U X E M B O U R G
L'Associé Unique décide de nommer Monsieur Richard Hyam, né le 25 mars 1963 à Hillingdon, Royaume-Uni, avec
adresse professionnelle au 10, Chemin de Blandonnet, 1214 Vernier, Suisse, en tant que gérant de la Société pour une
durée indéterminée et avec effet immédiat.
En conséquence de ce qui précède, le conseil de gérance de la Société est maintenant composé comme suit:
- Monsieur Michael Richard Peterson, gérant
- Monsieur Richard Hyam, gérant
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de mille quatre cents
Euros (1.400.- EUR).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête de la partie
comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même partie comparante,
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte au mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire
par nom, prénom, état civil et domicile, ledit mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: E. TCHEN et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 avril 2014. Relation: LAC/2014/16816. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): C. FRISING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 7 mai 2014.
Référence de publication: 2014064574/132.
(140074359) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2014.
Haus & Garten Service S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9425 Vianden, 45, rue du Sanatorium.
R.C.S. Luxembourg B 186.801.
STATUTEN
Im Jahre zweitausend vierzehn, den fünfundzwanzigsten April.
Vor dem unterzeichneten Notar Pierre PROBST, mit dem Amtssitz zu Ettelbruck.
Ist erschienen:
Herr Reiner CICHON, Maurermeister, geboren am 15. April 1964 in Flensburg (Deutschland), wohnhaft in L-9425
VIANDEN, 45, rue du Sanatorium.
Welcher Erschienene den beurkundenden Notar ersucht, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie
folgt zu beurkunden:
Art. 1. Es wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Namen "HAUS & GARTEN SERVICE S.à r.l."
gegründet, welche dem Recht von Luxemburg, insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften
in seiner geänderten Fassung (das Gesetz), sowie der vorliegenden Satzung (die Satzung) unterliegen soll.
Art. 2. Der Gesellschaftssitz wird in der Gemeinde Vianden, Großherzogtum Luxemburg, errichtet.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros sowohl
im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates kann der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der
Gemeinde Vianden verlegt werden.
Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch dieses
Sitzes mit dem Ausland durch außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet wer-
den, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins
Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Maßnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft,
die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.
Die Bekanntmachung von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen Ge-
schäftsführung beauftragt sind.
86011
L
U X E M B O U R G
Art. 3. Gegenstand der Gesellschaft ist die Renovation und Bauleitung, sowie die Ausführung von Kleinarbeiten rund
ums Haus, Maler-, Lackierer-, Putz-, Tapezier-und Spachtelarbeiten, und die Verlegung von Bodenbelägen und Ausführen
von Gartenarbeiten und Reinigung von Gebäuden.
Des Weiteren ist die Gesellschaft berechtigt bewegliche und unbewegliche Güter zu erwerben, alle Geschäfte und
Tätigkeiten vorzunehmen und alle Maßnahmen zu treffen, welche mit dem Gegenstand der Gesellschaft mittelbar oder
unmittelbar zusammenhängen oder sich an Firmen im In-und Ausland zu beteiligen, mit besagten Rechtspersonen zusam-
menzuarbeiten, sowie Zweigniederlassungen zu errichten, sowie jede Art von Tätigkeit, welche mit dem Gesellschaftsz-
weck direkt oder indirekt zusarnmenhängt oder denselben fördem kann, auszuüben.
Art. 4. Die Gesellschaft hat eine unbegrenzte Dauer.
Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt zwolftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) und ist eingeteilt in hundertfün-
fundzwanzig (125) Geschäftsanteile zu je hundert Euro (EUR 100,-).
Art. 6. Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva sowie an den Gewinnen
und Verlusten der Gesellschaft.
Art. 7. Zwischen den Gesellschaftern sind die Gesellschaftsanteile frei übertragbar. Anteilsübertragungen unter Le-
benden an Nichtgesellschafter sind nur mit dem vorbedingten Einverständnis der Gesellschafter, welche wenigstens drei
Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, mög1ich.
Bei Todesfall konnen die Anteile an Nichtgesellschafter nur mit der Zustimmung der Anteilsbesitzer, welche mindes-
tens drei Viertel der den Überlebenden gehorenden Anteile vertreten, übertragen werden.
Art. 8. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen. Sie werden
von den Gesellschaftern ernannt und abberufen.
Die Gesellschafter bestimmen die Befugnisse der Geschäftsführer.
Falls die Gesellschafter nicht anders bestimmen, haben die Geschäftsführer säntliche Befugnisse, um unter allen Ums-
tänden im Namen der Gesellschaft zu handeln.
Der Geschäftsführer kann Spezialvollmachten erteilen, auch an Nichtgesellschafter, um für ihn und in seinem Namen
für die Gesellschaft zu handeln.
Art. 9. Bezüg1ich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft sind die Geschäftsführer als Beauftragte nur fur die Ausführung
ihres Mandates verantwortlich.
Art. l0. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Gesell-
schaft nicht auf.
Gläubiger, Berechtigte und Erben eines verstorbenen Gesellschafters können nie einen Antrag auf Siegelanlegung am
Gesellschaftseigentum oder an den Gesellschaftsschriftstücken stellen. Zur Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich an die,
in der letzten Bilanz, aufgeführten Werte halten.
Im Todesfalle eines Gesellschafters fallen dessen Gesellschaftsanteile an die bleibenden Gesellschafter und sind zum
Buchwert an den Nachfolger auszuzahlen.
Art. 11. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres. Ausnahmsweise beginnt
das erste Geschäftsjahr am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2014.
Art. 12. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen den
Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn-und Verlustrechnung.
Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar.
Dieser Nettogewinn wird wie folgt verteilt:
- fiinf Prozent (5,00%) des Gewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, gemäß den gesetzlichen Bestimnun-
gen,
- der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftem zur Verfügung.
Art. 13. Im Falle der Auflôsung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von den Gesellschaftem
emannten Liquidatoren, welche keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt.
Die Gesellschafter bestimmen über die Befugnisse und Bezüge der Liquidatoren.
Art. 14. Für alle Punkte, welche nicht in diesen Satzungen festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen
Bestimmungen.
<i>Zeichnung Deranteilei>
Die 125 Geschäftsanteile werden wie folgt gezeichnet:
Reiner CICHON, vorbenannt, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Anteile
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Anteile
86012
L
U X E M B O U R G
Die Gesellschaftsanteile wurden voll in barem Gelde eingezahlt, sodass ab heute der Gesellschaft die Summe von
zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) zur Verfügung steht, so wie dies dem unterzeichnenden Notar nachge-
wiesen wurde.
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Die Kosten und Gebühren, in irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer Gründung obliegen oder zur
Last gelegt werden, werden auf achthundertfünfzig Euro (EUR 850,-) abgeschätzt.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Anschließend an die Gründung hat der Gesellschafter sich zu einer außerordentlichen Generalversammlung eingefun-
den und folgende Beschlüsse gefasst:
1) Herr Reiner CICHON, vorbenannt, wird zum alleinigen Geschäftsführer für eine unbestimmte Dauer ernannt.
2) Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers.
3) Der Sitz der Gesellschaft ist in L-9425 Vianden, 45, rue du Sanatorium.
Der Notar hat den Erschienenen darauf aufmerksam gemacht, dass eine Handelsermächtigung, in Bezug auf den Ge-
sellschaftszweck, ausgestellt durch die luxemburgischen Behörden, vor jeder kommerziellen Tätigkeit erforderlich ist,
was der Erschienene ausdrücklich anerkennt.
Da nichts Weiteres aufder Tagesordnung stand, wurde die Generalversammlung geschlossen.
<i>Erklärung des Unterzeichneri>
Der Gesellschafter erklärt hiermit, dass er der dinglich Begünstigte der Gesellschaft, die Gegenstand dieser Urkunde
ist, im Sinne des Gesetzes vom 12. November 2004 in der abgeänderten Fassung, und bescheinigt, dass die Mittel / Güter /
Rechte die das Kapital der Gesellschaft bilden nicht von irgendeiner Tätigkeit, die nach Artikel 506-1 des Strafgesetzbuches
oder Artikel 8-1 des Gesetzes vom 19. Februar 1973 betreffend den Handel von Arzneimitteln und die Bekämpfung der
Drogenabhängigkeit oder einer terroristische Handlung stammen im Sinne des Artikels 135-5 des Strafgesetzbuches (als
Finanzierung des Terrorismus definiert).
WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen zu Ettelbruck, in der Amtsstube des instrumentierenden Notars, Datum wie
eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vomamen, Stand
und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: Reiner CICHON, Pierre PROBST.
Enregistré à Diekirch, le 30 avril 2014. Relation: DIE/2014/5430. Reçu soixante-quinze euros 75,00.- €.
<i>Le Receveuri> pd (signé): Recken.
FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Begehr und zum Zwecke der Veröffentlichung im
Memorial erteilt.
Ettelbrück, den 9. Mai 2014.
Référence de publication: 2014065040/115.
(140075822) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2014.
Fil'eau S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9698 Pommerloch, 19, route de Bastogne.
R.C.S. Luxembourg B 186.811.
STATUTS
L'an deux mille quatorze, le vingt-quatre avril.
Par-devant Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck,
Ont comparu:
1) Madame Filomena DE JESUS ANTUNES, repasseuse, née le 8 octobre 1970 à Silveira/Torres Vedras (Portugal),
demeurant à L-9125 Schieren, 140, route de Luxembourg;
2) Madame Myriam ANTUNES CORREIA, sans état, née le 25 juillet 1992 à Luxembourg, demeurant à L-9125 Schieren,
140, route de Luxembourg;
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à
responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui
pourront le devenir par la suite une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois qui sera régie par les lois y
relatives ainsi que par les présents statuts. La société à responsabilité limitée prend la dénomination de «FIL'EAU S.à r.l.».
86013
L
U X E M B O U R G
Art. 2. La société a pour objet l'exploitation d'un commerce de pressing et de nettoyage à l'eau;
- La participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations commerciales ou industrielle pouvant se
rattacher à l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, de commandite, de souscri-
ption ou d'achat de titres ou de droits sociaux, de fusion, d'alliance ou d'associations en participation ou autrement.
- Et, généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, mobilières et immobilières pou-
vant se rattacher directement ou indirectement à des objets spécifiés ou tout autre objet similaire ou connexe ou de
nature à favoriser le développement du patrimoine social.
Art. 3. Le siège social est établi dans la commune de Winseler.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés. La
société peut ouvrir des agences ou des succursales dans toutes les autres localités du pays et à l'étranger.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,00 €) , représenté par cent (100)
parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq Euros (125,00 €) chacune.
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-
naires.
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de
douze mille cinq cents Euros se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au
notaire instrumentaire qui le constate expressément.
Art. 6. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle du nombre des parts existantes dans l'actif
social et dans les bénéfices.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées à des non-associés
qu'avec l'agrément donné en assemblée des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 8. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.
Art. 9. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer
des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilans et inventaires de la société.
Art. 10. La société est administrée et gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, salariés ou gratuits, nommés
par l'assemblée des associés, qui fixe leurs pouvoirs et la durée de leur fonction. Ils peuvent à tout moment être révoqués
par l'assemblée des associés.
A moins que les associés n'en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom
de la société en toutes circonstances.
En tant que simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction aucune
obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; ils ne seront
responsables que de l'exécution de leur mandat.
Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts lui appartenant.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente; chaque associé peut se
faire représenter valablement aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles aient été adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux présents statuts doivent être prises à la majorité des
associés représentant les trois quarts du capital social.
Art. 13. L'année sociale commence le 1
er
janvier et finit le trente et un décembre de chaque année, à l'exception du
premier exercice qui commence le jour de la constitution et finira le trente et un décembre deux mille quatorze.
Art. 14. Chaque année, à la clôture de l'exercice, les comptes de la société sont arrêtés et la gérance dresse les comptes
sociaux, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société, communication de l'inventaire et du bilan.
Art. 16. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugées
nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.
Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition des associés.
Art. 17. En cas de dissolution de la société, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés, qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
86014
L
U X E M B O U R G
Art. 18. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, la partie comparante se réfère et se soumet aux
dispositions légales en vigueur régissant les sociétés à responsabilité limitée.
<i>Déclaration des comparantsi>
Le(s) associé(s) déclare(nt), en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être
le(s) bénéficiaire(s) réel(s) de la société faisant l'objet des présentes et certifie(nt) que les fonds/biens/ droits servant à la
libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités constituant
une infraction visée aux articles 506-1 du Code pénal et 8-1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article
135-5 du Code Pénal (financement du terrorisme).
<i>Fraisi>
Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approxi-
mativement à 850,00 €.
Attribution des parts sociales
Ces parts ont été toutes souscrites par les comparants prénommés comme suit:
Madame Filomena DE JESUS ANTUNES, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 parts
Madame Myriam ANTUNES CORREIA, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 parts
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Ensuite les associés représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont
réunis en Assemblée Générale Extraordinaire et ont pris les résolutions suivantes:
- L'adresse du siège social de la société est fixée à L-9698 Pommerloch, 19, route de Bastogne
- Est nommé gérant technique pour une durée indéterminée:
Madame Filomena DE JESUS ANTUNES , prénommée,
- Est nommé gérant administrative pour une durée indéterminée:
Madame Myriam ANTUNES CORREIA, prénommée,
- La société sera valablement engagée par la signature du gérant technique.
<i>Déclaration du notairei>
Le notaire a attiré l'attention des parties comparantes sur le fait que l'exercice de l'activité sociale prémentionnée
requiert le cas échéant l'autorisation préalable des autorités compétentes.
Rien d'autre n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée.
Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire par nom, prénoms usuels, état et
demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Filomena DE JESUS ANTUNES, Myriam ANTUNES CORREIA, Pierre PROBST.
Enregistré à Diekirch, Le 30 avril 2014. Relation: DIE/2014/5428. Reçu soixante-quinze euros 75,00-€.
<i>Le Receveuri> pd (signé): Recken.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande et aux fins de publication au Mémorial.
Ettelbruck, le 9 mai 2014.
Référence de publication: 2014065000/109.
(140076178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2014.
Compagnie Financière S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 101.843.
Par la présente, nous vous informons de notre décision de démissionner en tant que délégué à la gestion journalière
de votre société avec effet ce jour.
Luxembourg, le 22 avril 2014.
BPH FINANCE S.A.
Référence de publication: 2014064083/11.
(140075073) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2014.
86015
L
U X E M B O U R G
Synergryn S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 175.147.
Réf: L130028364
L'an deux mille quatorze, le trente avril,
Par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg,
ONT COMPARU:
1) Monsieur Stéphane LEHNING, dirigeant de société, né à Metz (France), le 23 avril 1975, demeurant au 112, rue
des carrières, F-57000 Metz;
2) Monsieur Lucien LEHNING, restaurateur, né à Metz (France), le 3 mars 1979, demeurant au 10, rue Dominique
Mâcherez, F-57070 Metz,
ici représenté par Monsieur Stéphane LEHNING, prénommé,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 29 avril 2014;
3) Monsieur Gérard LEHNING, retraité, né à Metz (France), le 8 juillet 1942, demeurant au 12, rue Dominique Mâ-
cherez, F-57070 Metz,
ici représenté par Monsieur Stéphane LEHNING, prénommé,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 29 avril 2014.
Les procurations signées ne varietur par le mandataire des comparants et par le notaire soussigné resteront annexées
au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Les comparants sont les seuls actionnaires de SYNERGRYN S.A., une société anonyme, ayant son siège social à L-1746
Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
175.147, constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 28 décembre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Association, numéro 721 du 25 mars 2013 (la Société).
Les statuts de la Société ont été modifiés en dernier lieu suivant acte du notaire soussigné en date du 28 décembre
2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association, numéro 826 du 8 avril 2013.
Lesdits comparants, représentés comme indiqués ci-avant, ont prié le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
- Dans l'acte de l'assemblée générale extraordinaire du 28 décembre 2012 (n°1092/12 du répertoire), il y avait lieu de
préciser dans la première résolution que «Monsieur Stéphane Lehning et Monsieur Lucien Lehning s'engagent à conserver
les titres reçus en contrepartie de leur apport jusqu'au 1
er
février 2026», de sorte que la première résolution doit se
lire comme suit:
<i>«Première résolutioni>
L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de vingt millions
sept cent cinquante-trois mille sept cent soixante-trois euros (EUR 20.753.763) pour le porter de son montant actuel de
trente-deux millions huit cent trente-deux mille deux cent trente-quatre euros (EUR 32.832.234) représenté par trente-
deux millions huit cent trente-deux mille deux cent trente-quatre (32.832.234) actions d'une valeur nominale de un euro
(EUR 1) chacune, jusqu'à un montant de cinquante-trois millions cinq cent quatre-vingt-cinq mille neuf cent quatre-vingt-
dix-sept euros (EUR 53.585.997) par l'émission de vingt millions sept cent cinquante-trois mille sept cent soixante-trois
(20.753.763) actions nouvelles de la Société ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune.
Monsieur Stéphane Lehning et Monsieur Lucien Lehning s'engagent à conserver les titres reçus en contrepartie de leur
apport jusqu'au 1
er
février 2026.»
Réquisition est faite d'opérer cette rectification partout où il y a lieu.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, ledit mandataire a signé avec le notaire
la présente minute.
Signé: S. LEHNING et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 mai 2014. LAC / 2014 / 20412. Reçu douze euros €12,-.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): FRISING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.
Luxembourg, le 9 mai 2014.
Référence de publication: 2014065324/53.
(140075830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2014.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
86016
Aerium Place de Paris S.à r.l.
Argos S.A.
Ascot Luxembourg Holdings 1 S.à r.l.
Bellroad Investments (Luxembourg) S.à r.l.
BRE/Eschborn III Manager S.à.r.l.
BRE/Eschborn IV Manager S.à.r.l.
BRE/Eschborn V Manager S.à.r.l.
BRE/Essen II Manager S.à.r.l.
BRE/Essen I Manager S.à.r.l.
BRE/Munich IV Manager S.à.r.l.
Bull Fund
Buro-Lietaer S.à r.l.
Cabinet Comptable et Fiscal du Sud S.A.
Cabot NHUMO Holdings I S.à r.l.
Canoubi S.A.
Canoubi S.A.
Catalis
CETP Co-Investment S.à r.l.
CLdN Bulk II S.A.
CMB Global Lux
Coiffure NOSBUSCH S.à r.l.
Comenius Trading and Consulting S.A.
Compagnie Financière S.A.
Concept.Com S.A.
C.O.R.A. Soparfi S.A.
Créa-Tifs Coiffure S.à r.l.
Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A.
Ekdhall SA
Fil'eau S.à r.l.
Haus & Garten Service S.à r.l.
Kato S.à r.l.
Kite Fund Sicav
Melchior Selected Trust
M&S Coiffure s. à r.l.
Nylda
Simran Mediatech S.A.
Synergryn S.A.
Tappa Holding S.à r.l.
Technical Concepts Luxembourg
Temma S.à r.l.
Vector Holdings S.à r.l.
WSHP GP S.à r.l.
Yluv S.à r.l.