logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1689

1

er

 juillet 2014

SOMMAIRE

Banque Havilland S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81026

Barbara International S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

81026

Batiplan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81045

Bativia.Lux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81045

Cafe L'Italiano Vero S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

81044

Cortland Holdings S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

81044

Digital Services XVII (GP) S.à r.l.  . . . . . . . .

81045

Digital Services XVIII S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

81034

Do Way S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81061

Electrical Components International S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81026

Hampshire S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81068

Milch-Union Hocheifel Luxemburg

G.m.b.H.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81071

Orco Germany S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81056

Safindi Re S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81027

SAS Institute S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81028

Schorndorf Investments S.A.  . . . . . . . . . . . .

81028

SHCO 20 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81028

SHL Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

81027

Solicom S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81030

Somak (Europe) S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81031

Sopartag S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81033

Survicam S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81027

Taurus Euro Retail Finance S.à r.l.  . . . . . . .

81027

Taurus Euro Retail Holding S.à r.l.  . . . . . . .

81029

Technique Ibérie S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

81029

Technovaa Holdings S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

81032

Tersicore Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81032

Tetragono S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81033

T-I-Q s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81031

Top Auto S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81030

Universe, The CMI Global Network Fund

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81072

V2 Architecture s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81031

Valoneo Europe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81029

Vitreclean-Services S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

81030

Vitreclean-Services S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

81032

Vitreclean-Services S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

81072

V Telecom Investment General Partner

SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81030

W.BNK AG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81068

Whitehall European RE 3 S.à r.l. . . . . . . . . .

81029

Whitehall European RE 4 S.à r.l. . . . . . . . . .

81031

Whitehall European RE 5 S.à r.l. . . . . . . . . .

81032

Whitehall European RE 6 S.à r.l. . . . . . . . . .

81033

Winland International Petroleum S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81033

81025

L

U X E M B O U R G

Banque Havilland S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 147.029.

Le Bilan au 31 Décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 avril 2014.

<i>Pour Banque Havilland S.A.
Signature

Référence de publication: 2014059810/12.
(140069081) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2014.

Electrical Components International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 142.421.

EXTRAIT

Il résulte des décisions de l'associé unique de la Société en date du 16 avril 2014 que la société RSM Audit Luxembourg,

ayant son siège social au 6 rue Adolphe L-1116 Luxembourg et enregistrée au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 113621 a été nommée, en tant que Réviseur d'Entreprises agréé, et ce jusqu'à l'assemblée
générale ordinaire statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2013.

Luxembourg, le 28 avril 2014.

Pour extrait conforme
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014059946/16.
(140069053) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2014.

Barbara International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 159.621.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait

Il résulte d'un acte d'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (clôture de liquidation) de la société «BAR-

BARA INTERNATIONAL S.A.», reçu par Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché
de Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché
de Luxembourg, en date du 16 avril 2014, enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 22 avril 2014. Relation: EAC/2014/5618.

- que la société «BARBARA INTERNATIONAL S.A.» (la «Société»), société anonyme, établie et ayant son siège social

au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section
B sous le numéro 159 621,

constituée suivant acte notarié en date du 10 mars 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

numéro 1210 du 6 juin 2011,

se trouve à partir de la date du 16 avril 2014 définitivement liquidée, l'assemblée générale extraordinaire prémen-

tionnée faisant suite à celle du 31 mars 2014 aux termes de laquelle la Société a été dissoute anticipativement et mise en
liquidation avec nomination d'un liquidateur, en conformité avec les article 141 et suivants de la Loi du 10 août 1915.
concernant les sociétés commerciales, telle qu'amendée, relatifs à la liquidation des sociétés.

- que les livres et documents sociaux de la Société dissoute seront conservés pendant le délai légal (5 ans) au siège

social de la Société dissoute, en l'occurrence au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 28 avril 2014.

Référence de publication: 2014059811/26.
(140069068) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2014.

81026

L

U X E M B O U R G

SHL Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 29.118.231,50.

Siège social: L-8080 Bertrange, 35, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 155.387.

Les comptes annuels au 31/10/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 Février 2014.

Référence de publication: 2014059538/10.
(140068582) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2014.

Survicam S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1932 Luxembourg, 44, rue Auguste Letellier.

R.C.S. Luxembourg B 162.149.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014059516/10.
(140068974) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2014.

Taurus Euro Retail Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 114.173.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Taurus Euro Retail Finance S.à r.l.
Signatures

Référence de publication: 2014059558/11.
(140068944) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2014.

Safindi Re S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 11, route des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 162.691.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 25 avril 2014 tenue au 74, rue de Merl, L-2146 Luxembourg

L'Assemblée a pris les résolutions suivantes:
- L'Assemblée décide de renommer comme administrateurs:
* M. Philippe Vereecken, Président
* M. Tom Lenaerts, Administrateur
* Mme Els Verbraecken, Administrateur
* M. Dany Rasschaert, Administrateur
Leurs mandats expireront à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle de 2015 qui aura à statuer sur les comptes de

l'exercice social de 2014.

- L'Assemblée nomme Deloitte Audit S.à.r.l, ayant son siège social au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, comme

réviseur d'entreprises agréé. Ce mandat viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale à tenir en 2015 et qui aura
à statuer sur les comptes de l'exercice de 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014059520/23.
(140068632) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2014.

81027

L

U X E M B O U R G

Schorndorf Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 129.505.

EXTRAIT

Il résulte d'un procès-verbal d'une assemblée générale ordinaire tenue en date du 16 avril 2013 que:
L'assemblée décide de reconduire le mandat de l'administrateur-unique détenu par Madame Yulia Kurakina, née le 5

avril 1960 à Moscou, demeurant à L-2273 Luxembourg - 4A, rue de l'Ouest.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en l'an 2018.
L'assemblée décide de reconduire le mandat du commissaire aux comptes détenu par la société FIDU-CONCEPT

SARL, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B38.136, avec siège social au 36,
avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en l'an 2018.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2014059526/17.
(140068447) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2014.

SHCO 20 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 8.362.500,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 154.697.

<i>Extrait des résolutions du gérant unique datées du 20 mars 2014

En date du 20 mars 2014, le gérant unique de la Société a décidé de transférer le siège social de la Société au 6, rue

Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg avec effet immédiat.

Nous  vous  prions  également  de  bien  vouloir  prendre  note  du  changement  d'adresse  du  gérant  unique  Intertrust

Management (Luxembourg) S.à r.l., et ce avec effet au 28 février 2014:

6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 avril 2014.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014059537/18.
(140068508) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2014.

SAS Institute S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 250.000,00.

Siège social: L-8010 Strassen, 204, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 77.390.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 23 avril 2014

En date du 23 avril 2014, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- de prendre connaissance de la démission de Monsieur Patrick VAN DEVEN de son mandat de gérant unique de la

Société avec effet au 22 avril 2014;

- de nommer Monsieur Gijsbert Theodoor Wilhelmus BOERS, né le 20 août 1963 à Rhenen, Pays-Bas, résidant pro-

fessionnellement à l'adresse suivante: 6, Hertenbergstraat, 3080 Tervuren, Belgique en tant que nouveau gérant unique
de la Société avec effet au 23 avril 2014 et ce pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 avril 2014.

SAS Institute S.à r.l
Signature

Référence de publication: 2014059524/19.
(140068516) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2014.

81028

L

U X E M B O U R G

Technique Ibérie S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 176.514.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014059561/9.
(140068777) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2014.

Taurus Euro Retail Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 111.578.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Taurus Euro Retail Holding S.à r.l.
Signatures

Référence de publication: 2014059559/11.
(140068943) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2014.

Valoneo Europe, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 170.192.

EXTRAIT

En date du 26 mars 2014, l'associé unique a pris les résolutions suivantes:
- La démission de Monsieur Freddy de Petter, en tant que gérant B, est acceptée avec effet au 31 janvier 2014.
- La démission de Madame Barbara Neuerburg, en tant que gérante B, est acceptée avec effet au 31 janvier 2014.
Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 28 avril 2014.

Référence de publication: 2014059588/14.
(140068597) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2014.

Whitehall European RE 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.484.300,00.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 110.335.

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 17 avril 2014 a décidé d'accepter:
- la démission avec effet au 19 avril 2014 de Véronique Menard en qualité de gérant de la Société, ayant son adresse

professionnelle au 133, Peterborough Court, Fleet Street, GB-EC4A 2BB Londres, Royaume-Unis.

Le Conseil de Gérance sera, à partir du 19 avril 2014, composé comme suit:
- GS Lux Management Services S.à r.l., Gérant
- Marielle STIJGER, Gérant
- Dominique LE GAL, Gérant
- Michael FURTH, Gérant
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société
Dominique Le Gal
<i>Gérant

Référence de publication: 2014059617/20.
(140068500) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2014.

81029

L

U X E M B O U R G

Top Auto S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3258 Bettembourg, 8, rue Fernand Mertens.

R.C.S. Luxembourg B 103.526.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014059579/10.
(140068694) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2014.

Solicom S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9911 Troisvierges, 9, rue de Drinklange.

R.C.S. Luxembourg B 100.219.

Les comptes annuels au 31 mars 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014059545/10.
(140068400) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2014.

Vitreclean-Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 20, rue Astrid.

R.C.S. Luxembourg B 98.701.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour Vitreclean-Services S.à r.l.
Fideco S.A.

Référence de publication: 2014059592/12.
(140068050) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2014.

V Telecom Investment General Partner SA, Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 171.498.

<i>Extrait des résolutions du conseil d'administration du 25 avril 2014

En date du 25 avril 2014, le conseil d'administration de la Société a décidé de transférer le siège social de la Société

du 13-15 avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, et ce avec effet au 3
mars 2014. Nous vous prions également de bien vouloir prendre note du changement d'adresse des administrateurs
suivants avec effet au 3 mars 2014:

- Hille-Paul Schut, Administrateur de l'actionnaire A, avec adresse professionnelle au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453

Luxembourg;

- Joost Tulkens, Administrateur de l'actionnaire A, avec adresse professionnelle au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453

Luxembourg;

- Vladimir Mornard, Administrateur de l'actionnaire B, avec adresse professionnelle au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 avril 2014.

Sophie Zintzen
<i>Mandataire

Référence de publication: 2014059587/22.
(140068110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2014.

81030

L

U X E M B O U R G

V2 Architecture s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8448 Steinfort, 7, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 107.573.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014059605/10.
(140068386) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2014.

Somak (Europe) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9706 Clervaux, 2A, route d'Eselborn.

R.C.S. Luxembourg B 74.332.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014059546/10.
(140068973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2014.

T-I-Q s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8311 Capellen, 98, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 177.110.

Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 28 avril 2014.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE ACCURA S.A.
<i>Experts comptables et fiscaux
Signature

Référence de publication: 2014059557/14.
(140068979) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2014.

Whitehall European RE 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 3.593.575,00.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 128.511.

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 17 avril 2014 a décidé d'accepter:
- la démission avec effet au 19 avril 2014 de Véronique Menard en qualité de gérant de la Société, ayant son adresse

professionnelle au 133, Peterborough Court, Fleet Street, GB-EC4A 2BB Londres, Royaume-Unis.

Le Conseil de Gérance sera, à partir du 19 avril 2014, composé comme suit:
- GS Lux Management Services S.à r.l., Gérant
- Marielle STIJGER, Gérant
- Dominique LE GAL, Gérant
- Michael FURTH, Gérant
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société
Dominique Le Gal
<i>Gérant

Référence de publication: 2014059618/20.
(140068499) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2014.

81031

L

U X E M B O U R G

Technovaa Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 170.390.

Monsieur Michel RAFFOUL a démissionné de son mandat d'administrateur B de la Société avec effet au 15 avril 2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 avril 2014.

Technovaa Holdings S.A.

Référence de publication: 2014059562/11.
(140068803) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2014.

Tersicore Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 20, rue Louvigny.

R.C.S. Luxembourg B 137.767.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 décembre 2013.

SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2014059564/11.
(140068321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2014.

Vitreclean-Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 20, rue Astrid.

R.C.S. Luxembourg B 98.701.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour Vitreclean-Services S.à r.l.
Fideco S.A.

Référence de publication: 2014059593/12.
(140068052) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2014.

Whitehall European RE 5 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 3.593.575,00.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 128.509.

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 17 avril 2014 a décidé d'accepter:
- la démission avec effet au 19 avril 2014 de Véronique Menard en qualité de gérant de la Société, ayant son adresse

professionnelle au 133, Peterborough Court, Fleet Street, GB-EC4A 2BB Londres, Royaume-Unis.

Le Conseil de Gérance sera, à partir du 19 avril 2014, composé comme suit:
- GS Lux Management Services S.à r.l., Gérant
- Marielle STIJGER, Gérant
- Dominique LE GAL, Gérant
- Michael FURTH, Gérant
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société
Dominique Le Gal
<i>Gérant

Référence de publication: 2014059619/20.
(140068498) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2014.

81032

L

U X E M B O U R G

Sopartag S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 64.820.

Le Bilan au 30.06.2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014059547/10.
(140068343) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2014.

Tetragono S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1260 Luxembourg, 5, rue de Bonnevoie.

R.C.S. Luxembourg B 82.490.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

TETRAGONO S.A.

Référence de publication: 2014059572/10.
(140068739) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2014.

Winland International Petroleum S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: USD 16.730,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 167.464.

Nous vous prions de bien vouloir prendre note que le nom du gérant B, Monsieur Wu CHENGLIANG est Chengliang

WU.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 avril 2014.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014059634/14.
(140068520) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2014.

Whitehall European RE 6 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.264.525,00.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 128.510.

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 17 avril 2014 a décidé d'accepter:
- la démission avec effet au 19 avril 2014 de Véronique Menard en qualité de gérant de la Société, ayant son adresse

professionnelle au 133, Peterborough Court, Fleet Street, GB-EC4A 2BB Londres, Royaume-Unis.

Le Conseil de Gérance sera, à partir du 19 avril 2014, composé comme suit:
- GS Lux Management Services S.à r.l., Gérant
- Marielle STIJGER, Gérant
- Dominique LE GAL, Gérant
- Michael FURTH, Gérant
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société
Dominique Le Gal
<i>Gérant

Référence de publication: 2014059620/20.
(140068497) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2014.

81033

L

U X E M B O U R G

Digital Services XVIII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 186.468.

STATUTES

In the year two thousand and fourteen, on the seventh of April,
Before us Maître Carlo Wersandt, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

THERE APPEARED:

Rocket Internet GmbH, a limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) existing under the laws of

Germany, registered with the commercial register at the local court of Charlottenburg, Germany, under no. HRB 109262
B, having its registered address at Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Germany,

here represented by Ms Alix van der Wielen, maître en droit, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a

proxy, given in Berlin, Germany on 25 March 2014.

Said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to

this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such  appearing  party  has  requested  the  officiating  notary  to  enact  the  deed  of  incorporation  of  a  private  limited

company (société à responsabilité limitée) which it wishes to incorporate with the following articles of association:

A. Name - Purpose - Duration - Registered office

Art. 1. Name - Legal Form. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name

Digital Services XVIII S.à r.l. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning
commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.

Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign

companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio in view of its realisation by sale, exchange or otherwise.

2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it

holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the
Company.

2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by

issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.

2.4 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities

which it considers useful for the accomplishment of these purposes.

Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of

managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution
of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution

of the board of managers.

4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances

or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
traordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwiths-
tanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

B. Share capital - Shares

Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), represented by twelve

thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.

81034

L

U X E M B O U R G

5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.3 The Company may redeem its own shares.

Art. 6. Shares.
6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of

the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.

Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection

by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.

7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall

appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.

7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given

by the shareholders at a majority of three quarters of the share capital.

7.5 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of

the transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

7.6 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject

to the approval of such transfer given by the surviving shareholders at a majority of three quarters of the share capital.
Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving
spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.

C. Decisions of the shareholders

Art. 8. Collective decisions of the shareholders.
8.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles

of association.

8.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
8.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise

conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case,
each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his
vote in writing.

8.4 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of

shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by
the sole shareholder.

Art. 9. General meetings of shareholders. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, at least

one general meeting of shareholders shall be held within six (6) months of the end of each financial year in Luxembourg
at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the convening notice of such meeting.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices
of meeting. If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived
any convening requirement, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 10. Quorum and vote.
10.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
10.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company's

shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share
capital. If this majority is not reached in a first meeting or proposed written resolution, the shareholders may be convened
a second time with the same agenda or receive such proposed written resolution a second time by registered letter,
decisions are validly adopted in so far as they are adopted by a majority of the votes validly cast whichever is the fraction
of the share capital represented.

Art. 11. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.

81035

L

U X E M B O U R G

Art. 12. Amendments of the articles of association. Any amendment of the articles of association requires the approval

of (i) a majority of shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.

D. Management

Art. 13. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
13.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers

form a board of managers.

13.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not

expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of
association is to be construed as a reference to the “sole manager”.

13.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any

actions necessary or useful to fulfil the Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the
Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.

Art. 14. Appointment, removal and term of office of managers.
14.1 The manager(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remune-

ration and term of office.

14.2 The managers shall be appointed and may be removed from office at any time, with or without cause, by a decision

of the shareholders representing more than half of the Company's share capital.

14.3 The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two (2) different classes, being class A

managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant
shareholders resolutions and the managers be identified with respect to the class they belong.

Art. 15. Vacancy in the office of a manager.
15.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or

otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the  replaced  manager by  the remaining  managers  until  the  next meeting of  shareholders which shall resolve  on  the
permanent appointment, in compliance with the applicable legal provisions.

15.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company's sole manager, such vacancy must be filled without undue

delay by the general meeting of shareholders.

Art. 16. Convening meetings of the board of managers.
16.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held

at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.

16.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four (24) hours at

least in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document
being sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location
determined in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.

16.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive

any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of
managers.

Art. 17. Conduct of meetings of the board of managers.
17.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not

need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

17.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may

appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any
such meeting.

17.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either

in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.

17.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other

means of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis
and allowing an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a
participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.

17.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or

represented at a meeting of the board of managers.

17.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,

if any, shall not have a casting vote. In the event where the general meeting of shareholders has appointed different classes

81036

L

U X E M B O U R G

of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only be validly
taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which may be
represented).

17.7. The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in

writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be
the date of the last signature.

Art. 18. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
18.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by

the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. In the event the general meeting of
shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers), such minutes
shall be signed by one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation). Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman,
if any, or by any two (2) managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of
managers (namely class A managers and class B managers), such copies or excerpts shall be signed by one (1) class A
manager and one (1) class B manager (including by way of representation).

18.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or

excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.

Art. 19. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the

signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers;
in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers
and class B managers), the Company will only be validly bound by the joint signatures of at least one (1) class A manager
and one (1) class B manager (including by way of representation) or (ii) by the joint signatures or the sole signature of
any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such
delegation.

E. Audit and supervision

Art. 20. Auditor(s).
20.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company

shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.

20.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting

of shareholders.

20.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
20.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d'entreprises agréé

(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies' register and the
accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.

20.5. An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its

approval.

F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends

Art. 21. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end

on the thirty-first of December of the same year.

Art. 22. Annual accounts and allocation of profits.
22.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of

the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.

22.2. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve.

This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten
per cent (10%) of the share capital of the Company.

22.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the

contributing shareholder agrees with such allocation.

22.4 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does

not exceed ten per cent (10%) of the share capital.

22.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the

remainder of the Company's profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.

22.6 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.

81037

L

U X E M B O U R G

Art. 23. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
23.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared

by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may
not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable
reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles
of association do not allow to be distributed.

23.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the share-

holders subject to the provisions of the Law and these articles of association.

G. Liquidation

Art. 24. Liquidation.
24.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the

liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders
deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided,
the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the
Company.

24.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the shareholders in proportion to the number of shares of the Company held by them.

H. Final clause - Governing law

Art. 25. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance

with the Law.

<i>Transitional provisions

1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 31 December

2014.

2. Interim dividends may be distributed during the Company's first financial year.

<i>Subscription and payment

The twelve thousand five hundred (12,500) shares issued have been subscribed by Rocket Internet GmbH, aforemen-

tioned, for the price of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.00).

The shares so subscribed are fully paid-up by a contribution in cash so that the amount of twelve thousand five hundred

euro (EUR 12,500) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

The total contribution in the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) is entirely allocated to the

share capital.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be

borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately one thousand one hundred
euro.

<i>Resolutions of the sole shareholder

The incorporating shareholder, representing the entire share capital of the Company and having waived any convening

requirements, has thereupon passed the following resolutions:

1. The address of the registered office of the Company is set at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of

Luxembourg.

2. The following person is appointed as class A manager of the Company for an unlimited term:
- Mr Christian SENITZ, born in Aschersleben, Germany, on 27 January 1978, professionally residing at Johannisstrasse

20, D-10117 Berlin.

The following person is appointed as class B manager of the Company for an unlimited term:
- Mr Ulrich BINNINGER, born in Trier, Germany, on 30 August 1966, professionally residing at 19, rue des Lilas,

L-8035 Strassen, Luxembourg.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,

this deed is worded in English followed by a German translation; at the request of the same appearing party and in case
of divergence between the English and the German text, the English version shall prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name

and residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

81038

L

U X E M B O U R G

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausendvierzehn, am siebten April.
Vor uns, Carlo Wersandt, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,

IST ERSCHIENEN:

Rocket Internet GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach deutschem Recht, eingetragen im Handels-

register des Amtsgerichts Charlottenburg, unter der Nummer HRB 109262 B, mit Sitz in Johannisstrasse 20, 10117 Berlin
Deutschland,

hier vertreten durch Alix van der Wielen, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht

vom 25. März 2014, ausgestellt in Berlin, Deutschland.

Besagte  Vollmacht,  welche  von  der  erschienenen  Partei  und  dem  unterzeichnenden  Notar  ne  varietur  paraphiert

wurde, wird der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.

Die erschienene Partei hat den amtierenden Notar ersucht, die Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung

(société à responsabilité limitée) zu beurkunden, welche sie mit der folgenden Satzung gründen möchte:

A. Name - Zweck - Dauer - Sitz

Art. 1. Name - Rechtsform. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée)

mit dem Namen Digital Services XVIII S.à r.l. (die “Gesellschaft”), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August
1915 über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Ge-

sellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder
auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kontrolle
und Entwicklung ihrer Beteiligungen im Hinblick auf deren Verwertung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Art.

2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder

Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören Garantien geben,
Sicherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.

2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere

durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und
Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheine bzw. Wertpapieren.

2.4 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur vornehmen

sowie solche, welche das geistige Eigentum betreffen oder im Zusammenhang mit Grundeigentum stehen und die ihr zur
Erreichung dieser Zwecke förderlich erscheinen.

Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden,

welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird.

Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in der Stadt Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Rates der Geschäftsführer

verlegt werden. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderli-
chen Art und Weise gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer im

Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.

4.4 Sollte der Rat der Geschäftsführer entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale

Entwicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an
ihrem  Gesellschaftssitz  beeinträchtigen  könnten,  so  kann  der  Gesellschaftssitz  bis  zur  endgültigen  Beendigung  dieser
außergewöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben
keine Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes
eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) aufgeteilt in zwölf-

tausendfünfhundert (12.500) Anteile mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Anteil.

5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-

zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.

81039

L

U X E M B O U R G

5.3 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen.

Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit jeweils dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht über-

schreiten darf.

6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs, die Insolvenz

oder ein vergleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.

Art. 7. Anteilsregister - Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden

kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.

7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten

wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft
ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.

7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.
7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern mit

einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden.

7.5 Jede Übertragung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten gemäß Artikel 1690 des Code Civil

wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung zugestimmt
hat.

7.6 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters an neue Gesellschafter nur mit Zustimmung von

Gesellschaftern mit einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden. Eine derartige Zu-
stimmung ist nicht erforderlich, wenn die Anteile an Eltern, Nachkommen oder den/die überlebende/n Ehepartner/in
übertragen werden oder jedem anderem gesetzlichen Erben des verstorbenen Gesellschafters.

C. Entscheidungen der Gesellschafter

Art. 8. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
8.1 Die Gesellschafterversammlung ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch das Gesetz und diese Satzung

übertragen wurden.

8.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.
8.3 Falls und solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, dürfen gemeinsame Ent-

scheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung vorbehalten wären, schriftlich gefasst werden. In diesem
Fall  erhält  jeder  Gesellschafter  den  Text  der  Beschlüsse  oder  Entscheidungen  in  ausformulierter  Form  und  übt  sein
Stimmrecht schriftlich aus.

8.4 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschriften

des Abschnitts XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jeder Bezug auf die „Gesellschafter-
versammlung“ in der vorliegenden Satzung als Bezug auf den Alleingesellschafter, je nach Zusammenhang und soweit
anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingesellschafter ausgeübt.

Art. 9. Gesellschafterversammlung. Falls die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, muss jährlich

innerhalb von sechs (6) Monaten vor dem Ende des Geschäftsjahres mindestens eine Gesellschafterversammlung in Lu-
xemburg am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort abgehalten werden, wie in der Einberufungsbekanntmachung
zu dieser Versammlung genauer bestimmt. Andere Gesellschafterversammlungen finden an dem Ort und zu der Zeit statt,
welcher in der entsprechenden Einberufungsbekanntmachung genauer bestimmt werden. Falls alle Gesellschafter in einer
Versammlung anwesend oder vertreten sind und auf sämtliche Einberufungsformalitäten verzichtet haben, kann die Ge-
sellschafterversammlung auch ohne vorherige Ankündigung oder Veröffentlichung abgehalten werden.

Art. 10. Quorum und Abstimmung.
10.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.
10.2 Vorbehaltlich anderer Regelungen dieser Satzung oder des Gesetzes, die ein höheres Mehrheitsverhältnis vor-

sehen, bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von Gesellschaftern, die mehr als die
Hälfte des Gesellschaftskapitals halten. Falls diese Mehrheit in einer ersten Gesellschafterversammlung oder einer ersten
schriftlichen Konsultation der Gesellschafter nicht erreicht wird, können die Anteilseigner ein weiteres Mal mit derselben
Tagesordnung einberufen werden oder per Einschreiben dieselben schriftlichen Beschlussvorschläge erhalten und Ent-
scheidungen werden wirksam mit der Mehrheit der wirksam abgegebenen Stimmen gefasst, unabhängig vom Anteil des
durch sie vertretenen Gesellschaftskapitals.

Art. 11. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.

81040

L

U X E M B O U R G

Art. 12. Änderung der Satzung. Eine Änderung der Satzung erfordert die Zustimmung (i) einer Mehrheit der Gesell-

schafter, die mindestens (ii) eine Mehrheit von drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertritt.

D. Geschäftsführung

Art. 13. Befugnisse des alleinigen Geschäftsführers -Zusammensetzung und Befugnisse des Rates der Geschäftsführer.
13.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Ge-

schäftsführer hat, bilden diese einen Rat der Geschäftsführer.

13.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „alleiniger Ge-

schäftsführer“ nicht ausdrücklich verwendet wird, ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Rat der Geschäftsführer“
als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer“ auszulegen.

13.3 Der Rat der Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse im Namen der Gesellschaft zu handeln

und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.

Art. 14. Ernennung, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
14.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung ernannt, welche ihre Bezüge und

Amtszeit festlegt.

14.2 Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund durch einen Beschluss von Gesellschaftern, die mehr als die

Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, ernannt oder abberufen werden.

14.3 Die Gesellschafterversammlung kann die Ernennung von Geschäftsführern zwei (2) unterschiedlicher Kategorien

beschließen, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Eine solche Klassifizierung
der Geschäftsführer muss ordnungsgemäß im Protokoll der betreffenden Gesellschafterbeschlüsse festgehalten und die
Geschäftsführer der Kategorie, der sie angehören, zugeordnet werden.

Art. 15. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
15.1 Scheidet ein Geschäftsführer durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Insolvenz, Rücktritt oder aus einem anderen Grund

aus seinem Amt aus, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen die ur-
sprüngliche Amtszeit nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesellschafterversammlung ausgefüllt werden,
welche im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die endgültige Ernennung entscheidet.

15.2  Für  den  Fall, dass der alleinige  Geschäftsführer aus  seinem Amt ausscheidet,  muss  die frei gewordene Stelle

unverzüglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.

Art. 16. Einladung zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
16.1 Der Rat der Geschäftsführer versammelt sich auf Einberufung eines beliebigen Geschäftsführers. Die Sitzungen

des Rates der Geschäftsführer finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.

16.2  Die  Geschäftsführer  werden  mindestens  vierundzwanzig  (24)  Stunden  vor  dem  für  die  Sitzung  anberaumten

Zeitpunkt zu jeder Sitzung des Rates der Geschäftsführer schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe
der Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Geschäftsführer
schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abgege-
ben haben, wobei eine Kopie eines solchen unterzeichneten Dokuments ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung
zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss
des Rates der Geschäftsführer bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.

16.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle

Einladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Rates
der Geschäftsführer diesen zugestimmt und diese unterzeichnen.

Art. 17. Durchführung von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
17.1 Der Rat der Geschäftsführer kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Rat der Ge-

schäftsführer kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise selbst ein Geschäftsführer sein muss
und der für die Protokollführung der Sitzungen des Rates der Geschäftsführer verantwortlich ist.

17.2 Sitzungen des Rates der Geschäftsführer werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Rates der Ge-

schäftsführer  geleitet.  In  dessen  Abwesenheit  kann  der  Rat  der  Geschäftsführer  ein  anderes  Mitglied  des  Rates  der
Geschäftsführer  durch  einen  Mehrheitsbeschluss  der  anwesenden  oder  vertretenen  Mitglieder  als  Vorsitzenden  pro
tempore ernennen.

17.3 Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer teilnehmen, indem er ein anderen

Geschäftsführer schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder durch ein anderes vergleichbares Kommunikationsmittel be-
vollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Geschäftsführer kann einen
oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.

17.4 Eine Sitzung des Rates der Geschäftsführer kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein

anderes Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu
hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel

81041

L

U X E M B O U R G

ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung gilt als am Sitz der Ge-
sellschaft abgehalten.

17.5 Der Rat der Geschäftsführer kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest die Mehrheit seiner

Mitglieder in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.

17.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Rates der Geschäftsführer

teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden,
hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme. Sofern die Gesellschafterversammlung jedoch unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden Beschlüsse des Rates der Geschäftsführer nur dann wirksam gefasst, wenn sie von der Mehrheit
der Geschäftsführer einschließlich mindestens eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsführers der
Kategorie B (oder deren Vertreter) gefasst werden.

17.7 Der Rat der Geschäftsführer kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung,

per Faxschreiben, E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Jeder Geschäftsführer kann seine
Zustimmung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreffenden
Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.

Art. 18. Protokoll von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer - Protokoll der Entscheidungen des alleinigen Ge-

schäftsführers.

18.1 Das Protokoll einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer wird vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer,

falls vorhanden oder, im Falle seiner Abwesenheit, vom Vorsitzenden pro tempore und dem Schriftführer (falls vorhanden)
oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche
Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kate-
gorie B), werden solche Protokolle durch einen (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einen (1) Geschäftsführer der
Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet. Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsver-
fahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer, falls
vorhanden, oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden solche Kopien oder Auszüge durch einen (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einen (1)
Geschäftsführer der Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet.

18.2 Die Entscheidungen des alleinigen Geschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom alleinigen

Geschäftsführer unterzeichnet wird. Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet.

Art. 19. Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber. Dritten Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Um-

ständen  durch  (i)  die  Unterschrift  des  alleinigen  Geschäftsführers  oder,  für  den  Fall,  dass  die  Gesellschaft  mehrere
Geschäftsführer hat, durch die gemeinsame Unterschrift zwei (2) beliebiger Geschäftsführer wirksam verpflichtet; sofern
die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer
der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B), wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift min-
destens  eines  (1)  Geschäftsführers  der  Kategorie  A  und  eines  (1)  Geschäftsführers  der  Kategorie  B  (oder  deren
Vertreter), oder (ii) durch die gemeinsamen Unterschriften oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/
denen eine Unterschriftsbefugnis durch den Rat der Geschäftsführer übertragen worden ist, wirksam verpflichtet.

E. Aufsicht und Prüfung der gesellschaft

Art. 20. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
20.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der

Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)). Die Gesellschafterversammlung
ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.

20.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
20.3 Die Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Recht der permanenten Überprüfung und Kontrolle aller Ge-

schäfte der Gesellschaft.

20.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember

2002  betreffend  das  Handelsregister  und  die  Buchhaltung  und  den  Jahresabschluss  von  Unternehmen,  in  der  jeweils
gültigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d'entreprise agréé(s)) ernennen, entfällt
die Funktion des Rechnungsprüfers.

20.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die

Gesellschafterversammlung abberufen werden.

F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinne - Abschlagsdividenden

Art. 21. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am

einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

81042

L

U X E M B O U R G

Art. 22. Jahresabschluss und Gewinne.
22.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Rat der Geschäftsführer erstellt im

Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und
Verlustrechnung.

22.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage

der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.

22.3  Durch  einen  Gesellschafter  erbrachte  Einlagen  in  Rücklagen  können  mit  Zustimmung  dieses  Gesellschafters

ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.

22.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage entsprechend herabgesetzt

werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.

22.5 Auf Vorschlag des Rates der Geschäftsführer bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den ge-

setzlichen  Vorschriften  und  den  Bestimmungen  dieser  Satzung  wie  der  verbleibende  Bilanzgewinn  der  Gesellschaft
verwendet werden soll.

22.6 Ausschüttungen an die Gesellschafter erfolgen proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehalt-

enen Anteile.

Art. 23. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
23.1 Der Rat der Geschäftsführer kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche

vom Rat der Geschäftsführer vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur
Verfügung stehen. Der ausschüttbare Betrag darf nicht die Summe der seit dem Ende des vergangenen Geschäftsjahres
angefallenen Gewinne, gegebenenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne und ausschüttbare Rücklagen, beziehungs-
weise vermindert durch vorgetragene Verluste oder Summen, die einer Rücklage zugeführt werden, welche nach dem
Gesetz von 1915 oder dieser Satzung nicht ausgeschüttert werden darf, übersteigen.

23.2 Das Agio, andere Kapitalreserven und andere ausschüttbare Rücklagen können, im Einklang mit den Bestimmungen

des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung, frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

G. Liquidation

Art. 24. Liquidation.
24.1 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Abwicklung durch

einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, die über die
Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit nichts anderes
bestimmt wird haben die Liquidatoren die weitestgehenden Rechte für die Verwertung der Vermögenswerte und die
Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

24.2 Der sich nach Verwertung der Vermögenswerte und Tilgung der Verbindlichkeiten ergebende Überschuss wird

an die Gesellschafter proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehaltenen Anteile verteilt.

H. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht

Art. 25. Anwendbares Recht. Für alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten gelten die Regelungen des

Gesetzes von 1915.

<i>Übergangsbestimmungen

1. Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember

2014.

2. Abschlagsdividenden können auch während des ersten Geschäftsjahres der Gesellschaft ausgeschüttet werden.

<i>Zeichnung und Zahlung

Die zwölftausendfünfhundert (12.500) ausgegebenen Anteile wurden durch Rocket Internet GmbH, vorbenannt, zum

Preis von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) gezeichnet.

Die Einlage für so gezeichnete Anteile wurde vollständig in bar erbracht, so dass der Gesellschaft ein Betrag in Höhe

von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) zur Verfügung steht, was dem unterzeichnenden Notar nachgewiesen
wurde.

Die gesamte Einlage von in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) wird vollständig dem Gesellschafts-

kapital zugeführt.

<i>Auslagen

Die der Gesellschaft aufgrund oder im Zusammenhang mit ihrer Gründung entstandenen Kosten, Gebühren, Honorare

und Auslagen werden auf tausendeinhundert Euro geschätzt.

81043

L

U X E M B O U R G

<i>Beschlüsse des Alleingesellschafters

Der Gründungsgesellschafter, welcher das gesamte Gesellschaftskapital repräsentiert und welcher auf eine formelle

Einberufungsbekanntmachung verzichtet, hat daraufhin folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Sitz der Gesellschaft ist in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
2. Die folgende Person wird für unbegrenzte Zeit als Geschäftsführer der Kategorie A der Gesellschaft ernannt:
- Herr Christian SENITZ, geboren am 27. Januar 1978 in Aschersleben, Deutschland, geschäftsansässig in Johannis-

strasse 20, D-10117 Berlin.

Die folgende Person wird für unbegrenzte Zeit als Geschäftsführer der Kategorie B der Gesellschaft ernannt:
- Herr Ulrich BINNINGER, geboren am 30. August 1966 in Trier, Deutschland, geschäftsansässig in 19, rue des Lilas,

L-8035 Strassen, Luxemburg.

Worüber diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen wurde.
Der beurkundende Notar, welcher die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit auf Ersuchen der erschienenen

Partei, dass diese Urkunde auf Anfrage der erschienenen Partei auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen
Übersetzung. Auf Ersuchen derselben erschienenen Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen
und dem deutschen Text, soll die englische Fassung vorrangig sein.

Nachdem das Dokument dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei verlesen wurde, welche dem Notar mit Na-

men, Vornamen und Wohnsitz bekannt ist, hat der Bevollmächtigte die Urkunde zusammen mit dem Notar unterzeichnet.

Signé: A. VAN DER WIELEN, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 10 avril 2014. LAC/2014/16998. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 2 mai 2014.

Référence de publication: 2014059111/569.
(140068626) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2014.

Cortland Holdings S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 174.059.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 29 avril 2014.

Référence de publication: 2014059863/10.
(140069252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2014.

Cafe L'Italiano Vero S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4018 Esch-sur-Alzette, 9, rue d'Audun.

R.C.S. Luxembourg B 150.598.

<i>Extrait des décisions des associés, prises en date du 30.01.2014.

1- Monsieur Domenico SELVAGGI, cède 33, (trente trois) parts sociales de la société
CAFE L'ITALIANO VERO sàrl
à Monsieur Ahmed CHEBOUKI, né à Valence le 13 octobre 1966, demeurant à 7 rue de l'Industrie à L-3843 Schifflange.
de sorte que le capital social est à présent réparti comme suit:
- Mr. Monsieur Ahmed CHEBOUKI détient la totalité du capital social soit: 100 ( cent ) parts sociales.
- Le mandat du gérant de Monsieur Domenico SELVAGGI prend fin ce jour même,
- Le mandat de gérant est donné à Monsieur Ahmed CHEBOUKI, afin qu'il assure la gérance de la société ce, à dater

de ce jour et pour une durée indéterminée.

- Il a tout pouvoir pour engager la société avec sa seule signature.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 30.01.2014.

Référence de publication: 2014059868/19.
(140069100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2014.

81044

L

U X E M B O U R G

Batiplan, Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 15, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 46.234.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014059828/9.
(140069419) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2014.

Bativia.Lux, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.

R.C.S. Luxembourg B 177.862.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014059829/9.
(140069168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2014.

Digital Services XVII (GP) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 186.428.

STATUTES

In the year two thousand and fourteen, on the seventh of April;
Before the undersigned notary Carlo WERSANDT, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg);

THERE APPEARED:

Digital Services XVII S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of Grand Duchy

of Luxembourg, having its registered office at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, regis-
tration with the Luxembourg Trade and Companies’ Register pending,

here represented by Ms Alix van der Wielen, maître en droit, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a

proxy, given in Berlin, Germany, on 7 April 2014, and in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 7 April 2014.

Said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to

this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such  appearing  party  has  requested  the  officiating  notary  to  enact  the  deed  of  incorporation  of  a  private  limited

company (société à responsabilité limitée) which it wishes to incorporate with the following articles of association:

A. Name - Purpose - Duration - Registered office

Art. 1. Name - Legal Form. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name

Digital Services XVII (GP) S.à r.l. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915
concerning commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.

Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign

companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio in view of its realisation by sale, exchange or otherwise.

2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it

holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the
Company.

2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by

issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.

2.4 The Company may also act as a partner with unlimited or limited liability for the debts and obligations of any

Luxembourg or foreign entity.

2.5 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities

which it considers useful for the accomplishment of these purposes.

Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.

81045

L

U X E M B O U R G

3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of

managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution
of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution

of the board of managers.

4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances

or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
traordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwiths-
tanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

B. Share capital - Shares

Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), represented by twelve

thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.

5.2 The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.3 The Company may redeem its own shares.

Art. 6. Shares.
6.1 The Company’s share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of

the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.

Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection

by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.

7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall

appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.

7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given

by the shareholders at a majority of three quarters of the share capital.

7.5 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of

the transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

7.6 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject

to the approval of such transfer given by the surviving shareholders at a majority of three quarters of the share capital.
Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving
spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.

C. Decisions of the shareholders

Art. 8. Collective decisions of the shareholders.
8.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles

of association.

8.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
8.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise

conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case,
each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his
vote in writing.

8.4 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of

shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending

81046

L

U X E M B O U R G

on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by
the sole shareholder.

Art. 9. General meetings of shareholders. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, at least

one general meeting of shareholders shall be held within six (6) months of the end of each financial year in Luxembourg
at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the convening notice of such meeting.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices
of meeting. If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived
any convening requirement, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 10. Quorum and vote.
10.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
10.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company’s

shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share
capital. If this majority is not reached in a first meeting or proposed written resolution, the shareholders may be convened
a second time with the same agenda or receive such proposed written resolution a second time by registered letter,
decisions are validly adopted in so far as they are adopted by a majority of the votes validly cast whichever is the fraction
of the share capital represented.

Art. 11. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.

Art. 12. Amendments of the articles of association. Any amendment of the articles of association requires the approval

of (i) a majority of shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.

D. Management

Art. 13. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
13.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers

form a board of managers.

13.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not

expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of
association is to be construed as a reference to the “sole manager”.

13.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any

actions necessary or useful to fulfil the Company’s corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the
Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.

Art. 14. Appointment, removal and term of office of managers.
14.1 The manager(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remune-

ration and term of office.

14.2 The managers shall be appointed and may be removed from office at any time, with or without cause, by a decision

of the shareholders representing more than half of the Company’s share capital.

14.3 The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two (2) different classes, being class A

managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant
shareholders resolutions and the managers be identified with respect to the class they belong.

Art. 15. Vacancy in the office of a manager.
15.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or

otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the replaced manager  by the remaining  managers  until  the  next  meeting  of  shareholders which  shall resolve on the
permanent appointment, in compliance with the applicable legal provisions.

15.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company’s sole manager, such vacancy must be filled without undue

delay by the general meeting of shareholders.

Art. 16. Convening meetings of the board of managers.
16.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held

at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.

16.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four (24) hours at

least in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document
being sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location
determined in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.

81047

L

U X E M B O U R G

16.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive

any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of
managers.

Art. 17. Conduct of meetings of the board of managers.
17.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not

need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

17.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may

appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any
such meeting.

17.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either

in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.

17.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other

means of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis
and allowing an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a
participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.

17.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or

represented at a meeting of the board of managers.

17.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,

if any, shall not have a casting vote. In the event where the general meeting of shareholders has appointed different classes
of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only be validly
taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which may be
represented).

17.7. The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in

writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be
the date of the last signature.

Art. 18. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
18.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by

the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. In the event the general meeting of
shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) under the joint
signature of one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation). Copies or excerpts
of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if any, or
by any two (2) managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers
(namely class A manager and class B manager) under the joint signatures of one (1) class A manager and one (1) class B
manager (including by way of representation).

18.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or

excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.

Art. 19. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the

signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers;
in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers
and class B managers), the Company will only be validly bound by the joint signatures of at least one (1) class A manager
and one (1) class B manager (including by way of representation) or (ii) by the joint signatures or the sole signature of
any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such
delegation.

E. Audit and Supervision

Art. 20. Auditor(s).
20.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company

shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.

20.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting

of shareholders.

20.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
20.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d’entreprises agréé

(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies’ register and the
accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.

81048

L

U X E M B O U R G

20.5. An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its

approval.

F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends

Art. 21. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end

on the thirty-first of December of the same year.

Art. 22. Annual accounts and allocation of profits.
22.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of

the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.

22.2. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve.

This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten
per cent (10%) of the share capital of the Company.

22.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the

contributing shareholder agrees with such allocation.

22.4 In case of a share capital reduction, the Company’s legal reserve may be reduced in proportion so that it does

not exceed ten per cent (10%) of the share capital.

22.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the

remainder of the Company’s profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.

22.6 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.

Art. 23. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
23.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared

by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may
not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable
reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles
of association do not allow to be distributed.

23.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the share-

holders subject to the provisions of the Law and these articles of association.

G. Liquidation

Art. 24. Liquidation.
24.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the

liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders
deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided,
the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the
Company.

24.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the shareholders in proportion to the number of shares of the Company held by them.

H. Final clause - Governing law

Art. 25. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance

with the Law.

<i>Transitional provisions

1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 31 December

2014.

2. Interim dividends may be distributed during the Company’s first financial year.

<i>Subscription and payment

The twelve thousand five hundred (12,500) shares issued have been subscribed by Digital Services XVII S.à r.l., afore-

mentioned, for the price of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500).

The shares so subscribed are fully paid-up by a contribution in cash so that the amount of twelve thousand five hundred

euro (EUR 12,500) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

The total contribution in the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) is entirely allocated to the

share capital.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be

borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately one thousand one hundred
euro.

81049

L

U X E M B O U R G

<i>Resolution of the sole shareholder

The incorporating shareholder, representing the entire share capital of the Company and having waived any convening

requirements, has thereupon passed the following resolutions:

1. The address of the registered office of the Company is set at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of

Luxembourg.

2. The following person is appointed as class A manager of the Company for an unlimited term:
- Mr Christian SENITZ, born in Aschersleben, Germany, on 27 January 1978, professionally residing at Johannisstrasse

20, D-10117 Berlin.

The following person is appointed as class B manager of the Company for an unlimited term:
- Mr Ulrich BINNINGER, born in Trier, Germany, on 30 August 1966, professionally residing at 19, rue des Lilas,

L-8035 Strassen, Luxembourg.

<i>Statement

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,

this deed is worded in English followed by a German translation; at the request of the same appearing party and in case
of divergence between the English and the German text, the English version shall prevail.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this

document.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name

and residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausendvierzehn, den siebten April.
Vor dem unterzeichneten Notar Carlo WERSANDT, mit dem Amtssitz in Luxemburg, (Großherzogtum Luxemburg);

IST ERSCHIENEN:

Digital Services XVII S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) nach dem

Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg, und
deren Eintragung im Luxemburger Handels-und Gesellschaftsregister noch aussteht,

hier vertreten durch Alix van der Wielen, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht

ausgestellt in Berlin, Deutschland, am 7. April 2014 und in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, am 7. April 2014.

Besagte  Vollmacht,  welche  von  der  erschienenen  Partei  und  dem  unterzeichnenden  Notar  ne  varietur  paraphiert

wurde, wird der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.

Die erschienene Partei hat den amtierenden Notar ersucht, die Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung

(société à responsabilité limitée) zu beurkunden, welche sie mit der folgenden Satzung gründen möchte:

A. Name - Zweck - Dauer - Sitz

Art. 1. Name - Rechtsform. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée)

mit dem Namen Digital Services XVII (GP) S.à r.l. (die „Gesellschaft”), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10.
August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Ge-

sellschaften, sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung
oder auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung,
Kontrolle und Entwicklung ihrer Beteiligungen im Hinblick auf deren Verwertung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige
Art.

2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder

Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören Garantien geben,
Sicherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.

2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere

durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und
Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheinen bzw. Wertpapieren.

2.4 Die Gesellschaft kann auch als Gesellschafterin für die Schulden und Verpflichtungen jeglicher luxemburgischen

und ausländischen Gesellschaft mit unbeschränkter oder beschränkter Haftung handeln.

2.5 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur vornehmen

sowie solche, welche das geistige Eigentum betreffen oder im Zusammenhang mit Grundeigentum stehen, und die ihr zur
Erreichung dieser Zwecke förderlich erscheinen.

81050

L

U X E M B O U R G

Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden,

welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird.

Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in der Stadt Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Rates der Geschäftsführer

verlegt werden. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderli-
chen Art und Weise gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer im

Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.

4.4 Sollte der Rat der Geschäftsführer entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale

Entwicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an
ihrem  Gesellschaftssitz  beeinträchtigen  könnten,  so  kann  der  Gesellschaftssitz  bis  zur  endgültigen  Beendigung  dieser
außergewöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben
keine Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes
eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) aufgeteilt in zwölf-

tausendfünfhundert (12.500) Anteile mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Anteil.

5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-

zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.

5.3 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen.

Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit jeweils dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht über-

schreiten darf.

6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs, die Insolvenz

oder ein vergleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.

Art. 7. Anteilsregister - Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden

kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.

7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten

wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft
ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.

7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.
7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern mit

einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden.

7.5 Jede Übertragung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten gemäß Artikel 1690 des Code Civil

wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung zugestimmt
hat.

7.6 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters an neue Gesellschafter nur mit Zustimmung von

Gesellschaftern mit einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden. Eine derartige Zu-
stimmung  ist  nicht  erforderlich,  wenn  die  Anteile  Eltern,  Nachkommen  oder  dem/der  überlebenden  Ehepartner/in
übertragen werden oder jedem anderen gesetzlichen Erben des verstorbenen Gesellschafters.

C. Entscheidungen der Gesellschafter

Art. 8. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
8.1 Die Gesellschafterversammlung ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch das Gesetz und diese Satzung

übertragen wurden.

8.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.

81051

L

U X E M B O U R G

8.3 Falls und solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, dürfen gemeinsame Ent-

scheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung vorbehalten wären, schriftlich gefasst werden. In diesem
Fall  erhält  jeder  Gesellschafter  den  Text  der  Beschlüsse  oder  Entscheidungen  in  ausformulierter  Form  und  übt  sein
Stimmrecht schriftlich aus.

8.4 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschriften

des Abschnitts XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jeder Bezug auf die „Gesellschafter-
versammlung“ in der vorliegenden Satzung als Bezug auf den Alleingesellschafter, je nach Zusammenhang und soweit
anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingesellschafter ausgeübt.

Art. 9. Gesellschafterversammlung. Falls die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, muss jährlich

innerhalb von sechs (6) Monaten vor dem Ende des Geschäftsjahres mindestens eine Gesellschafterversammlung in Lu-
xemburg am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort abgehalten werden, wie in der Einberufungsbekanntmachung
zu dieser Versammlung genauer bestimmt. Andere Gesellschafterversammlungen finden an dem Ort und zu der Zeit statt,
welcher in der entsprechenden Einberufungsbekanntmachung genauer bestimmt werden. Falls alle Gesellschafter in einer
Versammlung anwesend oder vertreten sind und auf sämtliche Einberufungsformalitäten verzichtet haben, kann die Ge-
sellschafterversammlung auch ohne vorherige Ankündigung oder Veröffentlichung abgehalten werden.

Art. 10. Quorum und Abstimmung.
10.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.
10.2 Vorbehaltlich anderer Regelungen dieser Satzung oder des Gesetzes, die ein höheres Mehrheitsverhältnis vor-

sehen, bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von Gesellschaftern, die mehr als die
Hälfte des Gesellschaftskapitals halten. Falls diese Mehrheit in einer ersten Gesellschafterversammlung oder einer ersten
schriftlichen Konsultation der Gesellschafter nicht erreicht wird, können die Anteilseigner ein weiteres Mal mit derselben
Tagesordnung einberufen werden oder per Einschreiben dieselben schriftlichen Beschlussvorschläge erhalten und Ent-
scheidungen werden wirksam mit der Mehrheit der wirksam abgegebenen Stimmen gefasst, unabhängig vom Anteil des
durch sie vertretenen Gesellschaftskapitals.

Art. 11. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.

Art. 12. Änderung der Satzung. Eine Änderung der Satzung erfordert die Zustimmung (i) einer Mehrheit der Gesell-

schafter, die mindestens (ii) eine Mehrheit von drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertritt.

D. Geschäftsführung

Art. 13. Befugnisse des alleinigen Geschäftsführers - Zusammensetzung und Befugnisse des Rates der Geschäftsführer.
13.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Ge-

schäftsführer hat, bilden diese einen Rat der Geschäftsführer.

13.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „alleiniger Ge-

schäftsführer“ nicht ausdrücklich verwendet wird ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Rat der Geschäftsführer“
als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer“ auszulegen.

13.3 Der Rat der Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, im Namen der Gesellschaft zu handeln

und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.

Art. 14. Ernennung, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
14.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung ernannt, welche ihre Bezüge und

Amtszeit festlegt.

14.2 Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund durch einen Beschluss von Gesellschaftern, die mehr als die

Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, ernannt oder abberufen werden.

14.3 Die Gesellschafterversammlung kann die Ernennung von Geschäftsführern zwei (2) unterschiedlicher Kategorien

beschließen, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Eine solche Klassifizierung
der Geschäftsführer muss ordnungsgemäß im Protokoll der betreffenden Gesellschafterbeschlüsse festgehalten und die
Geschäftsführer der Kategorie, der sie angehören, zugeordnet werden.

Art. 15. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
15.1 Scheidet ein Geschäftsführer durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Insolvenz, Rücktritt oder aus einem anderen Grund

aus seinem Amt aus, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen die ur-
sprüngliche Amtszeit nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesellschafterversammlung ausgefüllt werden,
welche im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die endgültige Ernennung entscheidet.

15.2  Für den  Fall,  dass  der  alleinige  Geschäftsführer  aus seinem Amt  ausscheidet, muss die  frei gewordene  Stelle

unverzüglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.

81052

L

U X E M B O U R G

Art. 16. Einladung zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
16.1 Der Rat der Geschäftsführer versammelt sich auf Einberufung eines beliebigen Geschäftsführers. Die Sitzungen

des Rates der Geschäftsführer finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.

16.2  Die  Geschäftsführer  werden  mindestens  vierundzwanzig  (24)  Stunden  vor  dem  für  die  Sitzung  anberaumten

Zeitpunkt zu jeder Sitzung des Rates der Geschäftsführer schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe
der Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Geschäftsführer
schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abgege-
ben haben, wobei eine Kopie eines solchen unterzeichneten Dokuments ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung
zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss
des Rates der Geschäftsführer bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.

16.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle

Einladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Rates
der Geschäftsführer diesen zugestimmt und diese unterzeichnet haben.

Art. 17. Durchführung von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
17.1 Der Rat der Geschäftsführer kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Rat der Ge-

schäftsführer kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise selbst ein Geschäftsführer sein muss
und der für die Protokollführung der Sitzungen des Rates der Geschäftsführer verantwortlich ist.

17.2 Sitzungen des Rates der Geschäftsführer werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Rates der Ge-

schäftsführer geleitet. In dessen Abwesenheit kann der Rat der Geschäftsführer einen anderen Geschäftsführer durch
einen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Mitglieder als Vorsitzenden pro tempore ernennen.

17.3 Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer teilnehmen, indem er einen anderen

Geschäftsführer schriftlich, per Faxschreiben, EMail oder ein durch ein anderes vergleichbares Kommunikationsmittel
bevollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Geschäftsführer kann einen
oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.

17.4 Eine Sitzung des Rates der Geschäftsführer kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein

anderes Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu
hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel
ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung gilt als am Sitz der Ge-
sellschaft abgehalten.

17.5 Der Rat der Geschäftsführer kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest die Mehrheit seiner

Mitglieder in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.

17.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Rates der Geschäftsführer

teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden,
hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme. Sofern die Gesellschafterversammlung jedoch unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden Beschlüsse des Rates der Geschäftsführer nur dann wirksam gefasst, wenn sie von der Mehrheit
der Geschäftsführer einschließlich mindestens eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsführers der
Kategorie B (oder deren Vertreter) gefasst werden.

17.7 Der Rat der Geschäftsführer kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung,

per Faxschreiben, E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Jeder Geschäftsführer kann seine
Zustimmung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreffenden
Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.

Art. 18. Protokoll von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer - Protokoll der Entscheidungen des alleinigen Ge-

schäftsführers.

18.1 Das Protokoll einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer wird vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer,

falls vorhanden oder, im Falle seiner Abwesenheit, vom Vorsitzenden pro tempore und dem Schriftführer (falls vorhanden)
oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche
Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kate-
gorie B), werden solche Protokolle durch einen (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einen (1) Geschäftsführer der
Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsver-
fahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer, falls
vorhanden, oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden solche Kopien oder Auszüge durch einen (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einen (1)
Geschäftsführer der Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet.

18.2 Die Entscheidungen des alleinigen Geschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom alleinigen

Geschäftsführer unterzeichnet wird. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet.

81053

L

U X E M B O U R G

Art. 19. Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Um-

ständen  (i)  durch  die  Unterschrift  des  alleinigen  Geschäftsführers  oder,  für  den  Fall,  dass  die  Gesellschaft  mehrere
Geschäftsführer hat, durch die gemeinsame Unterschrift von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern wirksam verpflichtet;
sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäfts-
führer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B), wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift
mindestens eines (1) Geschäftsführers der Kategorie A und eines (1) Geschäftsführers der Kategorie B (oder deren
Vertreter) oder (ii) durch die gemeinsamen Unterschriften oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/denen
eine Unterschriftsbefugnis durch den Rat der Geschäftsführer übertragen worden ist, wirksam verpflichtet.

E. Aufsicht und Prüfung der Gesellschaft

Art. 20. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
20.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der

Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)). Die Gesellschafterversammlung
ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.

20.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
20.3 Der Rechnungsprüfer hat ein unbeschränktes Recht der permanenten Überprüfung und Kontrolle aller Geschäfte

der Gesellschaft.

20.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember

2002  betreffend  das  Handelsregister  und  die  Buchhaltung  und  den  Jahresabschluss  von  Unternehmen,  in  der  jeweils
gültigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d’entreprise agréé(s)) ernennen, entfällt
die Funktion des Rechnungsprüfers.

20.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die

Gesellschafterversammlung abberufen werden.

F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinne - Abschlagsdividenden

Art. 21. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am

einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

Art. 22. Jahresabschluss und Gewinne.
22.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Rat der Geschäftsführer erstellt im

Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und
Verlustrechnung.

22.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage

der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.

22.3  Durch  einen  Gesellschafter  erbrachte  Einlagen  in  Rücklagen  können  mit  Zustimmung  dieses  Gesellschafters

ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.

22.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage entsprechend herabgesetzt

werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.

22.5 Auf Vorschlag des Rates der Geschäftsführer bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den ge-

setzlichen  Vorschriften  und  den  Bestimmungen  dieser  Satzung,  wie  der  verbleibende  Bilanzgewinn  der  Gesellschaft
verwendet werden soll.

22.6 Ausschüttungen an die Gesellschafter erfolgen proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehalt-

enen Anteile.

Art. 23. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
23.1 Der Rat der Geschäftsführer kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche

vom Rat der Geschäftsführer vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur
Verfügung stehen. Der ausschüttbare Betrag darf nicht die Summe der seit dem Ende des vergangenen Geschäftsjahres
angefallenen Gewinne, gegebenenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne und ausschüttbare Rücklagen, beziehungs-
weise vermindert durch vorgetragene Verluste oder Summen, die einer Rücklage zugeführt werden, welche nach dem
Gesetz von 1915 oder dieser Satzung nicht ausgeschüttert werden darf, übersteigen.

23.2 Das Agio, andere Kapitalreserven und andere ausschüttbare Rücklagen können, im Einklang mit den Bestimmungen

des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung, frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

G. Liquidation

Art. 24. Liquidation.
24.1 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Abwicklung durch

einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, die über die
Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit nichts anderes

81054

L

U X E M B O U R G

bestimmt wird haben die Liquidatoren die weitestgehenden Rechte für die Verwertung der Vermögenswerte und die
Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

24.2 Der sich nach Verwertung der Vermögenswerte und Tilgung der Verbindlichkeiten ergebende Überschuss wird

an die Gesellschafter proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehaltenen Anteile verteilt.

H. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht

Art. 25. Anwendbares Recht. Für alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten gelten die Regelungen des

Gesetzes von 1915.

<i>Übergangsbestimmungen

1. Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember

2014.

2. Abschlagsdividenden können auch während des ersten Geschäftsjahres der Gesellschaft ausgeschüttet werden.

<i>Zeichnung und Zahlung

Zwölftausendfünfhundert (12.500) Anteile wurden ordnungsgemäß von Digital Services XVII S.à r.l., vorbenannt, zum

Preis von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) gezeichnet.

Die Einlage für so gezeichnete Anteile wurde vollständig in bar erbracht, so dass der Gesellschaft ein Betrag in Höhe

von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) zur Verfügung steht, was dem unterzeichnenden Notar nachgewiesen
wurde.

Die gesamte Einlage in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) wird vollständig dem Gesellschaftskapital

zugeführt.

<i>Auslagen

Die der Gesellschaft aufgrund oder im Zusammenhang mit ihrer Gründung entstandenen Kosten, Gebühren, Honorare

und Auslagen werden auf tausendeinhundert Euro geschätzt.

<i>Beschlüsse des Gesellschafter

Die Gründungsgesellschafter, welcher das gesamte Gesellschaftskapital repräsentiert und welcher auf eine formelle

Einberufungsbekanntmachung verzichtet, haben daraufhin folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Sitz der Gesellschaft ist in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
2. Die folgende Person wird für unbegrenzte Zeit als Geschäftsführer der Kategorie A der Gesellschaft ernannt:
- Herr Christian SENITZ, geboren am 27. Januar 1978 in Aschersleben, Deutschland, geschäftsansässig in Johannis-

strasse 20, D-10117 Berlin.

Die folgende Person wird für unbegrenzte Zeit als Geschäftsführer der Kategorie B der Gesellschaft ernannt:
- Herr Ulrich BINNINGER, geboren am 30. August 1966 in Trier, Deutschland, geschäftsansässig in 19, rue des Lilas,

L-8035 Strassen, Luxemburg.

<i>Erklärung

Der beurkundende Notar, welcher die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit auf Ersuchen der erschienenen

Parteien, dass diese Urkunde auf Anfrage der erschienenen Partei auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen
Übersetzung. Auf Ersuchen derselben erschienenen Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und
dem deutschen Text, soll die englische Fassung vorrangig sein.

WORÜBER diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen wurde.
Nachdem das Dokument der Bevollmächtigten der erschienenen Parteien vorgelesen wurde, welche dem Notar mit

Namen, Vornamen und Wohnsitz bekannt ist, hat die Bevollmächtigte die Urkunde zusammen mit dem Notar unter-
zeichnet.

Signé: A. VAN DER WIELEN, C. WERSANDT
Enregistré à Luxembourg A.C., le 10 avril 2014. LAC/2014/17005. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 2 mai 2014.

Référence de publication: 2014059108/576.
(140068205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2014.

81055

L

U X E M B O U R G

Orco Germany S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 40, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 102.254.

In the year two thousand and fourteen, on the third day of the month of April;
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg);

THERE APPEARED:

Mr. Nicolas TOMMASINI, residing professionally in Paris, France, acting as authorised delegate of the board of directors

of ORCO GERMANY S.A. pursuant to the resolutions of the board of directors of 3 March 2014 (an extract of which
is attached to the Issue Decision referenced below) (the "Delegate"), represented by Mr. Jan MERCKX, lawyer, residing
professionally in Luxembourg pursuant to the decision of the Delegate of the board of directors of the Company dated
5 March 2014 (the "Issue Decision") (a copy of which, after having been signed ne varietur by the appearing person and
the undersigned notary, will be annexed to this document to be filed with it with the registration authorities).

The Delegate represented as aforesaid declared and required the notary to record that:
1) The company ORCO GERMANY S.A., a société anonyme incorporated under the laws of the Grand Duchy of

Luxembourg, having its registered office at 40, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
registered with the Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg under number B 102.254 (the "Company") has
been incorporated by deed of Me Henri HELLINCKX, then notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg,
dated 22 July 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1056 on 21 October 2004,
page 50649.

The articles of association of the Company (the "Articles") have been amended several times and for the last time by

a deed of the undersigned notary, on 3 January 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
number 320 on 5 February 2014, page 15338.

2) The corporate capital of the Company is fixed at thirty-four million four hundred and sixty-five thousand six hundred

and forty-four euros and fifty eurocents (EUR 34,465,644.50) represented by three hundred and forty-four million six
hundred and fifty-six thousand four hundred and forty-five (344,656,445) shares having a par value of ten eurocents (EUR
0.10), all fully paid-up (by 100%)

Pursuant to article 5.2 of the Articles, in addition to the issued and subscribed corporate capital of thirty-four million

four hundred and sixty-five thousand six hundred and forty-four euros and fifty eurocents (EUR 34,465,644.50), the
Company has also an authorised, but unissued and unsubscribed share capital set at seventy million four hundred and
eleven thousand four hundred and eighty-eight euros and eighty eurocents (EUR 70,411,488.80) (the "Authorised Capi-
tal").

The board of directors is authorised and empowered within the limits of the Authorised Capital to (i) realize any

increase of the share capital or equity of the Company with or without the issuance of new shares it being understood
that the board of directors is authorised to issue such new shares in one or several issues and (ii) issue bonds, preferred
equity certificates, warrants, options or other instruments convertible, exchangeable or exercisable into new shares and
to issue new shares further to the conversion or exercise of the above mentioned instruments, it being understood that
(a) if such instruments are issued before or during the period set forth in the paragraph below, the new shares upon the
conversion or exercise of such instruments may be issued after the expiry of said period and (b) the board of directors
is authorised to issue such new shares in one or several issues. For the avoidance doubt, any increase of the share capital
or equity of the Company, as well as any issue of bonds, preferred equity certificates, warrants, options or other instru-
ments convertible, exchangeable or exercisable into new shares decided by the Board of Directors prior to 26 April 2012
under the former authorised share capital of the Company but not realized, converted or exercised at this date remains
validly approved and can be realized, issued, converted or exercised under this new Authorised Capital.

Such authorisation conferred to the board of directors will expire five (5) years after the date of the general meeting

of shareholders held on 26 April 2012 and can be renewed in accordance with the applicable legal provisions, it being
understood that the board of directors can proceed to an increase of share capital or issue of the above mentioned
instruments as of the date of the general meeting of shareholders held on 26 April 2012.

The new shares and the instruments to be issued in accordance with the above provisions may be paid up through

contributions in cash or in kind, by the incorporation of reserves, issue premiums or retained earnings, including in the
three latter cases in favor of new shareholders. The new shares to be issued in accordance with the provisions of article
5 of the Articles may be issued with or without share premium, it being understood that (i) such shares shall not be issued
at a price below the accounting par value and (ii) if the consideration payable to the Company for such newly issued
shares exceeds their accounting par value, the excess is to be treated as share premium in respect of such shares in the
books of the Company.

The board of directors is specially authorised to issue such new shares and, where applicable, the instruments to be

issued in accordance with the provisions of article 5 of the Articles without reserving (i.e. by cancelling or limiting) for
the existing shareholders the preferential right to subscribe for such shares and instruments.

81056

L

U X E M B O U R G

The board of directors is authorised to determine the place and date of the issue or the successive issues, the issue

price, the terms and conditions of the subscription of and paying up on the new shares (referred to in article 5 of the
Articles) and, if applicable, the duration, amortization, other rights (including early repayment), interest rates, conversion
rates and exchange rates of the aforesaid instruments (referred to in article 5 of the Articles) as well as all the other
conditions and terms of such instruments including as to their subscription, issue and payment.

The board of directors is authorised to do all things necessary to amend article 5 of the Articles in order to record

the change of issued and authorised share capital following any increase pursuant to article 5 of the Articles. The board
of directors is empowered to take or authorise the actions required for the execution and publication of such amendment
in accordance with the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended. Furthermore, the
board of directors may delegate to any duly authorised person, the duties of accepting subscriptions, conversions or
exchanges and receiving payment for shares, bonds, preferred equity certificates, warrants, options or instruments and
to do all things necessary to amend article 5 of the Articles in order to record the change of issued and authorised share
capital following any increase pursuant to article 5 of the Articles.

3) By resolutions dated 3 March 2014 (the "Resolutions"), the board of directors of the Company (i) approved in

principle the increase of the share capital of the Company, without reserving to the existing shareholders their preferential
subscription rights by cancelling their preferential subscription rights, pursuant to article 5.2 of the Articles, by a total
amount of seven million six hundred and sixty thousand euros (EUR 7,660,000.-), in order to raise it from its current
amount of thirty-four million four hundred and sixty-five thousand six hundred and forty-four euros and fifty eurocents
(EUR 34,465,644.50) to forty-two million one hundred and twenty-five thousand six hundred and forty-four euros and
fifty eurocents (EUR 42,125,644.50) by creating and issuing seventy-six million six hundred thousand (76,600,000) new
ordinary shares (the "New Shares" and each a "New Share") having a par value of ten eurocents (EUR 0.10) (the "Par
Value") each, at a subscription price of forty-seven eurocents (EUR 0.47) per New Share, any amount exceeding the Par
Value for each New Share being allocated to the share premium account of the Company and representing a global
amount of twenty-eight million three hundred and forty-two thousand euros (EUR 28,342,000.-) (the "Capital Increase"),
each of such New Shares to be subscribed by Stationway Properties Limited (the "Subscriber"), an international business
company incorporated in the Republic of Seychelles, with its registered office at Suite 13, 1 

st

 Floor, Oliaji Trade Centre,

Francis Rachel Street, Victoria, Mahe, Republic of Seychelles, identification N° 103784 and (ii) authorised, empowered
and instructed inter alia the Delegate, acting individually and with full power of substitution, to implement such Capital
Increase  under the  Authorised  Capital  of  the  Company  (as  it  may be  amended from  time  to  time)  in favour of  the
Subscriber, as soon as practicable after the receipt of the relevant subscription funds related to the Capital Increase from
the Subscriber, being understood however that the Capital Increase shall only be effective as of the date of the Issue
Decision by the Delegate.

4) After the receipt by the Company on 5 March 2014 of the relevant subscription funds related to the Capital Increase

from the Subscriber, pursuant to the Issue Decision by the Delegate and in accordance with the Resolutions, the share
capital of the Company was increased within the framework of the Authorised Capital, with effective date as of 5 March
2014, by cancelling the preferential subscription rights of the existing shareholders in respect of the New Shares, by an
amount of seven million six hundred and sixty thousand euros (EUR 7,660,000.-) from its current amount of thirty-four
million four hundred and sixty-five thousand six hundred and forty-four euros and fifty eurocents (EUR 34,465,644.50)
to forty-two million one hundred and twenty-five thousand six hundred and forty-four euros and fifty eurocents (EUR
42,125,644.50), through the creation and issuance of seventy-six million six hundred thousand (76,600,000) New Shares,
with a Par Value of ten eurocents (EUR 0.10) each, at a subscription price of forty-seven eurocents (EUR 0.47) per New
Share, fully paid up against a global contribution amount of thirty-six million two thousand euros (EUR 36,002,000.-) for
all the New Shares issued.

Such New Shares were subscribed and fully paid up through a contribution in cash by the Subscriber for a global amount

of thirty-six million two thousand euros (EUR 36,002,000.-). The global contribution of thirty-six million two thousand
euros (EUR 36,002,000.-) was allocated as follows: seven million six hundred and sixty thousand euros (EUR 7,660,000.-)
was allocated to the share capital of the Company and twenty-eight million three hundred and forty-two thousand euros
(EUR 28,342,000.-) was allocated to the share premium account of the Company.

Therefore, the Company had at its free and entire disposal on 5 March 2014 the amount of thirty-six million two

thousand euros (EUR 36,002,000.-) as was certified to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

5) As a consequence of the Capital Increase and the issue of the New Shares on 5 March 2014, the subscribed share

capital of the Company presently amounts to forty-two million one hundred and twenty-five thousand six hundred and
forty-four euros and fifty eurocents (EUR 42,125,644.50), divided into four hundred and twenty-one million two hundred
and fifty-six thousand four hundred and forty-five (421,256,445) shares having a Par Value of ten eurocents (EUR 0.10).

Therefore, the first sentence of article 5, paragraph 5.1 of the Articles of the Company is amended accordingly and

shall now read as follows:

5.1. Issued Share Capital. The corporate capital is fixed at forty-two million one hundred and twenty-five thousand

six hundred and forty-four euros and fifty eurocents (EUR 42,125,644.50), represented by four hundred and twenty-one
million two hundred and fifty-six thousand four hundred and forty-five (421,256,445) shares having a par value of ten
eurocents (EUR 0.10)."

81057

L

U X E M B O U R G

Furthermore, consequently to the Capital Increase within the framework of the Authorised Capital, the amount of

the Authorised Capital as set out in the first sentence of paragraph 5.2 of the Articles of the Company has been decreased
to sixty-two million seven hundred and fifty-one thousand four hundred and eighty-eight euros and eighty eurocents (EUR
62,751,488.80) so that the first sentence of paragraph 5.2 of the Articles is amended accordingly and shall now read as
follows:

5.2. Authorised Capital. In addition to the issued and subscribed corporate capital of forty-two million one hundred

and twenty-five thousand six hundred and forty-four euros and fifty eurocents (EUR 42,125,644.50), the Company has
also an authorised, but unissued and unsubscribed share capital set at sixty-two million seven hundred and fifty-one
thousand four hundred and eighty-eight euros and eighty eurocents (EUR 62,751,488.80) (the "Authorised Capital")."

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present stated increase of capital, are estimated at six thousand six hundred Euros (EUR 6,600.-).

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the appearing

person the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this do-

cument.

The document having been read to the appearing person, whom is known to the notary by her name, surname, civil

status and residence, the said person appearing signed together with the notary, the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L’an deux mille quatorze, le troisième jour du mois d'avril;
Par-devant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg);

A COMPARU:

Monsieur Nicolas TOMMASINI, résidant professionnellement à Paris, France, agissant en qualité de délégué autorisé

du conseil d'administration de ORCO GERMANY S.A. en vertu des résolutions prises par le conseil d'administration le
3 mars 2014 (un extrait de ces résolutions étant annexé à la Décision d'Emettre mentionnée ci-dessous) (le "Délégué"),
représenté par Jan MERCKX, juriste, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu de la décision du Délégué du
conseil d'administration de la Société en date du 5 mars 2014 (la "Décision d'Emettre") (copie de laquelle après avoir été
signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec
lui aux formalités de l’enregistrement).

Le Délégué, représenté tel que susmentionné, a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter que:
1) La société ORCO GERMANY S.A., une société anonyme constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg,

ayant son siège social au 40, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 102.254 (la "Société") a été constituée
suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, alors notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg, en
date du 22 juillet 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1056 du 21 octobre 2004,
page 50649.

Les statuts de la Société (les "Statuts") ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu

par le notaire instrumentant en date du 3 janvier 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro
320 du 5 février 2014, page 15338.

2) Le capital social de la Société est fixé à trente-quatre millions quatre cent soixante-cinq mille six cent quarante-

quatre euros et cinquante centimes d'euros (34.465.644,50 EUR) représenté par trois cent quarante-quatre millions six
cent  cinquante-six  mille  quatre  cent  quarante-cinq  (344.656.445)  actions  ayant  une  valeur  nominale  de  dix  centimes
d’euros (EUR 0,10), toutes entièrement libérées (à 100%).

En vertu de l’article 5.2 des Statuts, en plus du capital émis et souscrit de la Société de trente-quatre millions quatre

cent soixante-cinq mille six cent quarante-quatre euros et cinquante centimes d'euros (34.465.644,50 EUR), la Société
dispose également d'un capital social autorisé, mais non émis et non souscrit, fixé à soixante-dix millions quatre cent onze
mille quatre cent quatre-vingt-huit euros et quatre-vingts centimes d'euros (70.411.488,80 EUR) (le "Capital Autorisé").

Le conseil d'administration est autorisé et habilité dans les limites du Capital Autorisé à (i) réaliser toute augmentation

du capital social ou des capitaux propres de la Société avec ou sans l’émission d'actions nouvelles étant entendu que le
conseil d'administration est autorisé à émettre de telles actions nouvelles en une ou plusieurs émissions et (ii) émettre
des obligations, certificats de parts privilégiées, warrants, options ou autres instruments convertibles, échangeables ou
exerçables en actions nouvelles et d'émettre des actions nouvelles suite à la conversion ou l’exercice des instruments
mentionnés ci-dessus, étant entendu que (a) si de tels instruments sont émis avant ou pendant la période indiquée dans
le paragraphe ci-dessous, les actions nouvelles au titre de la conversion ou de l’exercice de ces instruments peuvent être

81058

L

U X E M B O U R G

émises après expiration de ladite période et (b) que le conseil d'administration soit autorisé à émettre de telles actions
nouvelles en une ou plusieurs émissions. A toutes fins utiles, toute augmentation du capital social ou des capitaux propres
de la Société, ainsi que toute émission d'obligations, certificats d'actions privilégiées, warrants, options ou autres instru-
ments convertibles, échangeables ou exerçables en actions nouvelles décidées par le conseil d'administration avant le 26
avril 2012 dans le cadre de l’ancien capital autorisé de la Société mais non réalisées, converties ou exercées à cette date
demeurent valablement approuvées et peuvent être réalisées, émises, converties ou exercées en vertu de ce nouveau
Capital Autorisé.

Cette autorisation conférée au conseil d'administration prendra fin cinq (5) ans après la date de l’assemblée générale

des actionnaires tenue le 26 avril 2012 et peut être renouvelée conformément aux dispositions légales applicables, étant
entendu que le conseil d'administration peut procéder à une augmentation de capital ou à l’émission des instruments
mentionnés ci-dessus à compter de la date de l’assemblée générale des actionnaires tenue le 26 avril 2012.

Les  actions  nouvelles  et  les  instruments  devant  être  émis  conformément  aux  dispositions  ci-dessus  peuvent  être

libérées  par  apport  en  numéraire  ou  en  nature,  par  incorporation  de  réserves,  primes  d'émission  ou  bénéfices  non
répartis, y compris dans les trois derniers cas au bénéfice de nouveaux actionnaires. Les actions nouvelles à émettre
conformément aux dispositions de l’article 5 des Statuts peuvent être émises avec ou sans prime d'émission, étant entendu
que (i) ces actions ne doivent pas être émises à un prix inférieur au pair comptable et (ii) si la contrepartie payable à la
Société pour ces actions nouvellement émises excède leur pair comptable, l’excédent doit être traité comme prime
d'émission à l’égard de ces actions dans les comptes de la Société.

Le conseil d'administration est spécialement autorisé à émettre ces nouvelles actions et, le cas échéant, les instruments

devant être émis conformément aux dispositions de l’article 5 des Statuts sans réserver (c'est à dire en annulant ou en
limitant) aux actionnaires existants le droit préférentiel de souscrire à de telles actions et de tels instruments.

Le conseil d'administration est autorisé à déterminer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le

prix d'émission, les modalités et les conditions de la souscription et du paiement des nouvelles actions (mentionnées dans
l’article 5 des Statuts) et, si applicable, la durée, l’amortissement, les autres droits (y compris le remboursement anticipé),
les taux d'intérêt, les taux de conversion et taux de change des instruments précités (mentionnés dans l’article 5 des
Statuts) ainsi que tous les autres termes et conditions de ces instruments, incluant notamment leur souscription, leur
émission et leur paiement.

Le conseil d'administration est autorisé à prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier l’article 5 des Statuts

afin d'enregistrer la modification du capital social autorisé et émis suivant toute augmentation au titre de l’article 5 des
Statuts. Le conseil d'administration est habilité à prendre ou autoriser les mesures requises en vue de l’exécution et de
la publication d'une telle modification conformément à la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés com-
merciales, telle que modifiée. En outre, le conseil d'administration peut déléguer à toute personne dûment autorisée, les
fonctions d'accepter les souscriptions, conversions ou échanges et recevoir les paiements pour les actions, obligations,
certificats de parts privilégiées, warrants, options ou instruments et de prendre toutes les mesures nécessaires afin de
modifier l’article 5 des Statuts dans le but d'enregistrer la modification du capital social autorisé et émis suivant toute
augmentation conformément à l’article 5 des Statuts.

3) Par des résolutions prises en date du 3 mars 2014 (les "Résolutions"), le conseil d'administration de la Société (i) a

approuvé en principe l’augmentation du capital social de la Société, sans réserver aux actionnaires existants leurs droits
préférentiels de souscription en leur supprimant leurs droits préférentiels de souscription, conformément à l’article 5.2
des Statuts, pour un montant total de sept millions six cent soixante mille euros (7.660.000,- EUR), afin de l’élever de son
montant actuel de trente-quatre millions quatre cent soixante-cinq mille six cent quarante-quatre euros et cinquante
centimes d'euros (34.465.644,50 EUR) à quarante-deux millions cent vingt-cinq mille six cent quarante-quatre euros et
cinquante centimes d'euros (42.125.644,50 EUR), par la création et l’émission de soixante-seize millions six cent mille
(76.600.000) nouvelles actions ordinaires (les "Nouvelles Actions" et chacune une "Nouvelle Action") ayant une valeur
nominale de dix centimes d'euros (0,10 EUR) (la "Valeur Nominale") chacune, au prix d'émission de quarante-sept cen-
times d'euros (0,47 EUR) par Nouvelle Action, tout montant excédant la Valeur Nominale de chaque Nouvelle Action
étant alloué au compte de prime d'émission de la Société et représentant un montant global de vingt-huit millions trois
cent quarante-deux mille euros (28.342.000,- EUR) (l’ "Augmentation de Capital"), chacune de ces Nouvelles Actions
devant être souscrites par Stationway Properties Limited (le "Souscripteur"), une société d'affaire internationale consti-
tuée dans la République des Seychelles, ayant son siège social à Suite 13, 1 

st

 Floor, Oliaji Trade Centre, Francis Rachel

Street, Victoria, Mahe, République des Seychelles, identification N° 103784 et (ii) a autorisé, donné pouvoir et chargé
inter alia, le Délégué, agissant individuellement et avec plein pouvoir de substitution, de procéder à l’Augmentation de
Capital par le biais du Capital Autorisé de la Société (tel qu'il peut être modifié de temps à autre) en faveur du Souscripteur,
le plus tôt possible après réception des fonds de souscription relatifs à l’Augmentation de Capital versés par le Souscri-
pteur, étant entendu cependant que l’Augmentation de Capital ne sera effective qu'à partir de la date de la Décision
d'Emettre du Délégué.

4) Après réception par la Société le 5 mars 2014 des fonds de souscription relatifs à l’Augmentation de Capital versés

par le Souscripteur, conformément à la Décision d'Emettre du Délégué et conformément aux Résolutions, le capital social
de la Société a été augmenté dans le cadre du Capital Autorisé, avec effet au 5 mars 2014, en supprimant les droits
préférentiels de souscription des actionnaires existants relatifs aux Nouvelles Actions, par un montant de sept millions

81059

L

U X E M B O U R G

six cent soixante mille euros (7.660.000,- EUR), de son montant actuel de trente-quatre millions quatre cent soixante-
cinq mille six cent quarante-quatre euros et cinquante centimes d'euros (34.465.644,50 EUR) à quarante-deux millions
cent vingt-cinq mille six cent quarante-quatre euros et cinquante centimes d'euros (42.125.644,50 EUR), par la création
et l’émission de soixante-seize millions six cent mille (76.600.000) Nouvelles Actions, ayant une Valeur Nominale de dix
centimes d'euros (0,10 EUR) chacune, à un prix d'émission de quarante-sept centimes d'euros (0,47 EUR) par Nouvelle
Action, entièrement libérées par un apport total d'un montant de trente-six millions deux mille euros (36.002.000,-EUR)
pour toutes les Nouvelles Actions émises.

De telles Nouvelles Actions ont intégralement été souscrites et libérées par un apport en numéraire du Souscripteur

pour un montant total de trente-six millions deux mille euros (36.002.000,- EUR). L'apport total de trente-six millions
deux mille euros (36.002.000,- EUR) a été alloué comme suit: sept millions six cent soixante mille euros (7.660.000,- EUR)
ont été alloués au capital de la Société et vingt-huit millions trois cent quarante-deux mille euros (28.342.000,- EUR) ont
été alloués au compte de prime d'émission de la Société.

De ce fait, la Société disposait librement et entièrement au 5 mars 2014 du montant de trente-six millions deux mille

euros (36.002.000,- EUR) tel que certifié au notaire soussigné, qui le reconnaît expressément.

5) En conséquence de l’Augmentation de Capital et de l’émission des Nouvelles Actions le 5 mars 2014, le capital social

souscrit de la Société s'élève actuellement à quarante-deux millions cent vingt-cinq mille six cent quarante-quatre euros
et cinquante centimes d'euros (42.125.644,50 EUR), divisé en quatre cent vingt et un millions deux cent cinquante-six
mille quatre cent quarante-cinq (421.256.445) actions ayant une Valeur Nominale de dix centimes d’euros (0,10 EUR).

Ainsi la première phrase de l’article 5, paragraphe 5.1 des Statuts de la Société est modifiée en conséquence, et se lira

dorénavant comme suit:

5.1. Capital Social Emis. Le capital social est fixé à quarante-deux millions cent vingt-cinq mille six cent quarante-

quatre euros et cinquante centimes d'euros (42.125.644,50 EUR) représenté par quatre cent vingt et un millions deux
cent  cinquante-six  mille  quatre  cent  quarante-cinq  (421.256.445)  actions  ayant  une  valeur  nominale  de  dix  centimes
d’euros (0,10 EUR)."

En outre, en conséquence de l’Augmentation de Capital dans le cadre du Capital Autorisé, le montant du Capital

Autorisé tel qu'indiqué dans la première phrase du paragraphe 5.2 des Statuts de la Société a été réduit à soixante-deux
millions  sept  cent  cinquante  et  un  mille  quatre  cent  quatre-vingt-huit  euros  et  quatre-vingts  centimes  d'euros
(62.751.488,80 EUR) de telle sorte que la première phrase du paragraphe 5.2 des Statuts est modifiée en conséquence
et se lira dorénavant comme suit:

5.2. Capital autorisé. En plus du capital émis et souscrit de la Société de quarante-deux millions cent vingt-cinq mille

six cent quarante-quatre euros et cinquante centimes d'euros (42.125.644,50 EUR), la Société dispose également d'un
capital social autorisé, mais non émis et non souscrit, fixé à soixante-deux millions sept cent cinquante et un mille quatre
cent quatre-vingt-huit euros et quatre-vingts centimes d'euros (62.751.488,80 EUR) (le "Capital Autorisé")."

<i>Frais

Les frais, coûts, rémunération, et autres charges de quelque nature que ce soit, qui doivent être portés au compte de

la Société par suite de cette augmentation de capital, sont estimés à six mille six cents euros (6.600,- EUR).

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne com-

parante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de cette même personne et en cas
de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, lequel est connu du notaire instrumentaire par son nom,

prénom, état et demeure, ledit comparant a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J. MERCKX, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 7 avril 2014. LAC/2014/16408. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société;

Luxembourg, le 2 mai 2014.

Référence de publication: 2014059440/285.

(140068192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2014.

81060

L

U X E M B O U R G

Do Way S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 28B, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 186.425.

STATUTES

In the year two thousand fourteen, on the twenty-eighth of March,
Before Us M 

e

 Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned,

THERE APPEARED:

- Mr Wenjiang DU, a Chinese citizen and holder of a Chinese passport, number G5I09I689, medical and health mas-

sager, born on August 29, 1960, in Heilongjiang, People's Republic of China (hereinafter, “P.R.C.”), residing at V. Kreves
pr. 82A - 43 LT - 50247, Kaunas, Lithuania,

- Mr Wei DU, a Chinese citizen and holder of Chinese passport, number GI8052602, company manager, born on

January 7, 1987, in in Heilongjiang, P.R.C., residing at 28B, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg,

Such appearing persons have requested the officiating notary to document the deed of incorporation of a private

limited liability company (société à responsabilité limitée) which they deem to incorporate herewith and the articles of
association of which are established as follows:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares

hereafter issued, a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name of “Do Way S.à
r.l.” (the "Company"), which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and more particularly by
the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended (the “Law"), as well as by the present articles of
association (the "Articles”).

Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be

transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be, by the
board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand
Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single member or the general meeting of members adopted in the
manner required for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad

by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single
manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or
events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstan-
ces.  Such  temporary  measures  shall  have  no  effect  on  the  nationality  of  the  Company,  which,  notwithstanding  the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Objects.
3.1. The Company's main object is to exploit beauty institutes providing Chinese traditional relaxation massage and

all activities related to oriental body care and well-being.

3.2. The Company may carry out domestic and international trade of Asian products.
3.3. The Company may exploit Asian restaurants.
3.4. The Company may also carry out all commercial activities, in accordance with the provisions of the law of Sep-

tember 2, 2011 relating to the right of establishment and regulating the access to the occupations of craftsman, tradesman,
industrialist as well as certain liberal professions.

Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,

bankruptcy or any similar event affecting one or several of the members.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.
5.1. The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-), represented by

twelve thousand five hundred (12,500) shares in registered form with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, all
subscribed and fully paid-up.

81061

L

U X E M B O U R G

5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the

single member or, as the case may be, by the general meeting of members, adopted in the manner required for the
amendment of the Articles.

Art. 6. Shares.
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion

to the number of shares in existence.

6.2. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.3. Shares are freely transferable among members or, if there is no more than one member, to third parties.
If the Company has more than one member, the transfer of shares to non-members is subject to the prior approval

of the general meeting of members representing at least three quarters of the share capital of the Company.

A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,

the Company in accordance with article 1690 of the civil code.

For all other matters, reference is made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4. A members' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the

Law and may be examined by each member who so requests.

6.5. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.

III. Management - Representation

Art. 7. Board of managers
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single member or the general

meeting of members which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will constitute a
board of managers. The manager(s) need not to be member(s).

7.2. The managers may be dismissed ad nutum.

Art. 8. Powers of the board of managers.
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of members fall

within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of
managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's
object.

8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either members or

not, by the manager, or if there is more than one manager, by the joint signature of two managers of the Company.

Art. 9. Proceedings of the board of managers.
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company's interests so requires or upon call of any manager at

the place indicated in the convening notice.

9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)

hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.

9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present

or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company.

9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his

proxy.

9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.

Resolutions of the board of managers are validly voted by the majority of those present or represented provided that
any resolution shall not validly be passed unless it is approved by the majority of its members. The resolutions of the
board of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.

9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or

by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.

9.7. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a

meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

Art. 10. Representation. The Company shall be bound in relation to third parties by the sole signature of any one of

the managers.

81062

L

U X E M B O U R G

Art. 11. Liability of the managers. The managers assume by reason of their mandate, no personal liability in relation to

any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with
these Articles as well as the applicable provisions of the Law.

III. General meetings of members

Art. 12. Powers and voting rights.
12.1. The single member assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of members.
12.2. Each member has voting rights commensurate to its shareholding.
12.3. Each member may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter,

telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of members.

Art. 13. Form - Quorum - Majority.
13.1. If there are not more than twenty-five members, the decisions of the members may be taken by circular resolution,

the text of which shall be sent to all the members in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or e-mail.
The members shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the members may appear on a
single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by members owning more than half of the

share capital.

13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the

majority of the members owning at least three quarters of the Company's share capital.

IV. Annual accounts - Allocation of profits

Art. 14. Accounting Year.
14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first

of December.

14.2. Each year, with reference to the end of the Company's accounting year, the Company's accounts are established

and the manager or, in case there is a plurality of managers, the board of managers shall prepare an inventory including
an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

14.3. Each member may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 15. Allocation of Profits.
15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation

and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5 %) of the net profits of the Company is
allocated to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share
capital.

15.2. The general meeting of members has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate

such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.

15.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the manager or the board of managers;
(ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient funds are available for distribution; it being

understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year,
increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to the statutory reserve;

(iii) the decision to pay interim dividends is taken by the sole member or the general meeting of members;
(iv) all necessary measures have been taken to ensure that the rights of the creditors of the Company are not threa-

tened.

V. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation.
16.1. In the event of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, who

do not need to be members, appointed by a resolution of the single member or the general meeting of members which
will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the member(s) or by
law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of the
liabilities of the Company.

16.2. The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be

paid to the member or, in the case of a plurality of members, the members in proportion to the shares held by each
member in the Company.

81063

L

U X E M B O U R G

VII. General provision

17. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these

Articles.

<i>Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on December 31, 2014.

<i>Subscription - Payment

Thereupon, Mr DU Wenjiang, hereby declares to have subscribed to six thousand two hundred and fifty (6,250) shares

of the share capital of the Company, representing half of the share capital, and declare to have fully paid up the six thousand
two hundred and fifty (6,250) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, by contribution in cash,

Mr DU Wei, hereby declares to have subscribed to six thousand two hundred and fifty (6,250) shares of the share

capital of the Company, representing half of the share capital, and declare to have fully paid up the six thousand two
hundred and fifty (6,250) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, by contribution in cash. Thus, the whole
share capital is fully paid up so that the amount of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) is at the disposal
of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand Euros.

<i>Resolutions of the general meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the general meeting of the members, representing the entirety

of the subscribed share capital, passed the following resolutions:

1. The following persons are appointed managers of the Company for an indefinite period:
- Mr Wenjiang DU, a Chinese citizen and holder of a Chinese passport number G5I09I689, medical and health massager,

born on August 29, 1960, in Heilongjiang, residing at V. Kreves pr. 82A - 43 LT - 50247, Kaunas, Lithuania,

- Mr Wei DU, a Chinese citizen and holder of Chinese passport number G I8052602, company manager, born on

January 7, 1987, in in Heilongjiang, , residing at 28B, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg,

2. The registered office of the Company is set at L-1140 Luxembourg, 28B, route d'Arlon.

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above

appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
persons, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the appearing persons, acting as said before, known to the notary by name, first

name, civil status and residence, the said persons have signed with us, the notary, and the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le vingt-huit mars;
Par devant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

soussigné;

ONT COMPARU:

- Mr Wenjiang DU, citoyen chinois détenteur d'un passeport chinois numéro G5I09I689, masseur thérapeute, né à

Heilongjiang, Chine, le 29 août 1960, demeurant à LT - 50247 Kaunas, Lituanie, 82A-43, V. Kreves pr,

- Mr Wei DU, citoyen chinois détenteur d'un passeport chinois numéro G I8052602, gérant de société, né à Heilong-

jiang, Chine le 7 janvier 1987, demeurant à L-1140 Luxembourg, 28B, route d'Arlon,

Lesquelles parties comparantes ont requis le notaire instrumentaire d'arrêter les statuts d'une société à responsabilité

limitée à constituer comme suit:

I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée

Art. 1 

er

 . Dénomination.  Il est établi entre les comparants et tous ceux qui pourront devenir détenteurs des parts

sociales ci-après créées une société à responsabilité limitée sous la dénomination: «Do Way S.à r.l.» (ci-après, la «Socié-
té»), qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après, la «Loi») et par les présents statuts (ci-après, les «Statuts»).

81064

L

U X E M B O U R G

Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la société est établi à Luxembourg-Ville, Grand-duché de Luxembourg. Il peut être transféré

dans les limites de la commune de Luxembourg par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil
de gérance. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé
unique ou de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, des

succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Lorsque le gérant unique ou le
conseil de gérance estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à
compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se produiront
ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces
circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui restera
une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social.
3.1. La Société a pour objet principal l'exploitation d'institut de beauté, massage et toutes les activités liées aux soins

et au bien-être du corps humains.

3.2. La Société pourra accomplir les activités du commerce national et international des produits asiatiques.
3.3. La Société peut exploiter des restaurants asiatiques.
3.3. La Société pourra également accomplir toutes les activités commerciales, en conformité avec les dispositions de

la loi du 2 septembre 2011 concernant le droit d'établissement et réglementant l'accès aux professions d'artisan, de
commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales.

Art. 4. Durée.
4.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l'interdiction, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite

ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-), représenté par douze mille cinq cents

(12.500) parts sociales sous forme nominative avec une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune, toutes entièrement
souscrites et libérées.

5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de

l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales.
6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le

nombre des parts sociales existantes.

6.2. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.

Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.3. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d'associé unique, à des tiers.
En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales à des non-associés n'est possible qu'avec l'agrément donné

en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

La cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle ait été notifiée à la Société ou

acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du code civil.

Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il

pourra être consulté par chaque associé.

6.5. La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites et aux conditions prévues par la

Loi.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Conseil de gérance.
7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par résolution de l'assemblée générale des associés

laquelle fixe la durée de leur mandat. Dans la mesure où plusieurs gérants sont nommés, ils constituent le conseil de
gérance composé d'un (1) ou plusieurs gérants qui ne sont pas nécessairement un/des associé(s).

7.2. Les gérants sont révocables ad nutum.

81065

L

U X E M B O U R G

Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance.
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs pour
effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social.

8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents,

associés ou non, par le gérant, ou s'il y a plus d'un gérant, par la signature conjointe de deux gérants.

Art. 9. Procédure.
9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un des

gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre)

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents

ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut
aussi être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque gérant de la Société donné par écrit soit en original, soit par
télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.

9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant

comme son mandataire.

9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou

représentée. Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à la majorité des voix des gérants présents ou
représentés. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou
représentés à la réunion.

9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout

autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s'entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la
réunion.

9.7. Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées

comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent être
apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou téléfax.

Art. 10. Représentation. La Société sera engagée à l'égard des tiers par la seule signature de l'un quiconque des gérants.

Art. 11. Responsabilité des gérants. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle

relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
pris en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.

IV. Assemblée générale des associés

Art. 12. Pouvoirs et droits de vote.
12.1. En cas d'associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l'assemblée générale des

associés.

12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par

écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.

Art. 13. Forme - Quorum - Majorité.
13.1. Lorsque le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises

par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex,
téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures
des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre
ou téléfax.

13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés

détenant plus de la moitié du capital social.

13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la

Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la
Société.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices

Art. 14. Exercice social.
14.1. L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.

81066

L

U X E M B O U R G

14.2. Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Sociétés sont arrêtés et le gérant ou, en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de
la Société.

14.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.

Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements

et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société qui sera
affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

15.2. L'assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l'affectation du solde restant du bénéfice net

annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à la réserve ou le reporter.

15.3. Des dividendes intérimaires pourront être distribués à tout moment dans les conditions suivantes:
(i) un état comptable ou un inventaire ou un rapport est dressé par le gérant ou le conseil de gérance;
(ii) il ressort de cet état comptable, inventaire ou rapport que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution,

étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à allouer
à la réserve légale;

(iii) la décision de payer les dividendes intérimaires est prise par l'associé unique ou l'assemblée générale des associés;
(iv) le paiement est fait dès lors qu'il est établi que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation.
16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémuné-
ration. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) associé(s) ou par la loi, les liquidateurs seront
investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué à

l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales détenues
par chacun d'eux dans la Société.

VII. Disposition générale

Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Disposition transitoire

La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2014.

<i>Souscription - Libération

Ensuite, Monsieur Wenjiang DU, déclare avoir souscrit à six mille deux cent cinquante (6.250) parts sociales du capital

social de la Société, représentant la moitié du capital social de la Société et avoir entièrement libéré les six mille deux
cent cinquante (6.250) parts sociales avec une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune, par versement en espèces,
Monsieur Wei DU, déclare avoir souscrit à six mille deux cent cinquante (6.250) parts sociales du capital social de la
Société, représentant la moitié du capital social de la Société et avoir entièrement libéré les six mille deux cent cinquante
(6.250) parts sociales avec une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune, par versement en espèces.

Ainsi, la totalité du capital social de la Société est entièrement libéré, de sorte que la somme de douze mille cinq cents

Euros (EUR 12.500,-) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît
expressément.

<i>Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de mille euros (EUR
1000.-)

<i>Résolutions de l'assemblée générale

Et aussitôt, l'assemblée générale des associés, représentants l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1. Les personnes suivantes sont nommées comme gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Wenjiang DU, citoyen chinois détenteur d'un passeport chinois numéro G5I09I689, masseur thérapeute,

né à Heilongjiang, Chine, le 29 août 1960, demeurant à LT - 50247 Kaunas Lituanie, 82A-43, V. Kreves pr,

- Monsieur Wei DU, citoyen chinois détenteur d'un passeport chinois numéro G I8052602, gérant de société, né à

Heilongjiang, Chine, le 7 janvier 1987, demeurant à L-1140 Luxembourg, 28B, route d'Arlon,

2. Le siège social de la Société est établi à L-1140 Luxembourg, 28B, route d'Arlon.

81067

L

U X E M B O U R G

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et le français, déclare par les présentes, qu'à la requête des

personnes comparantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes per-
sonnes comparantes, et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux personnes comparantes, agissant comme dit ci-avant , connues du notaire par nom,

prénom, état civil et domicile, lesdites personnes ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: W. DU, W. DU, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 1 

er

 avril 2014. LAC/2014/15122. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 28 avril 2014.

Référence de publication: 2014059113/383.
(140068166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2014.

W.BNK AG, Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 61.460.

Le Bilan au 31.12.2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014059607/10.
(140068342) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2014.

Hampshire S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 107.411.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

In the year two thousand fourteen, on the twenty-fifth day of April.
Before Maître Cosita DELVAUX, civil law notary residing in Redange-sur-Attert, Grand-Duchy of Luxembourg, un-

dersigned.

Is held

the Extraordinary General Shareholders' Meeting of the company HAMPSHIRE S.A., a société anonyme in liquidation,

having its registered office at 2, avenue Charles, L-1653 Luxembourg, incorporated on 19 April 2005 pursuant to a deed
received by Me Henri HELLINCKX, civil law notary then residing in Mersch, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés  et  Associations  number  844  of  5  September  2005,  registered  with  the  Luxembourg  Trade  and  Companies
register at section B under number 107411.

The Company has been put into liquidation by deed of the undersigned notary on 10 December 2013, with appointment

of CF Corporate Services, Luxembourg, as liquidator.

AUDIEX S.A., with registered office at 9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg, has been appointed as auditor to

the liquidation by deed under private seal dated 2 April 2014.

The meeting is opened and presided over by Mr Luc HANSEN, licencié en administration des affaires, with professional

address at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

The Chairman appoints as secretary Mrs Carine GRUNDHEBER, private employee, with professional address at 2,

avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

The Meeting elects as scrutineer Mr Marc ALBERTUS, private employee, with professional address at 2, avenue Charles

de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I) The agenda of the meeting is the following:
1. Auditor's report on liquidation.
2. Discharge to the former directors, to the statutory auditor, to the liquidator and to the auditor to liquidation for

their respective assignments.

3. Closing of the liquidation.

81068

L

U X E M B O U R G

4. Decision as to the place where the accounts and records of the company are to be deposited and retained during

the legal period of five years.

5. Powers to be given in view of the final settlement of the company's accounts and of the fulfilment of all formalities.
II) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their

shares are shown on an attendance list, which, signed by the shareholders present and by the proxies of the represented
shareholders, the members of the bureau of the meeting and by the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed at the same time by the registration authority.

The proxies given by the represented shareholders after having been signed "ne varietur" by the members of the

bureau of the meeting and by the undersigned notary will also remain annexed to the present deed.

III) As appears from the attendance list, the 1,200 (one thousand two hundred) shares representing the whole share

capital of the Company are present or duly represented at the present Extraordinary General Meeting.

IV) The Chairman states that the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on all the items

of the agenda.

After the foregoing has been approved by the Meeting, the same unanimously takes the following resolutions:

<i>First resolution

The Meeting, having taken notice of the report established by the auditor to liquidation, approves said report as well

as the liquidation accounts.

The said report, after signature "ne varietur" by the members of the bureau and the undersigned notary, will be attached

to the present deed to be registered with it.

<i>Second resolution

The Meeting gives full discharge to the former directors, to the statutory auditor, to the liquidator and to the auditor

to liquidation for their respective assignments.

<i>Third resolution

The Meeting pronounces the closing of the liquidation.

<i>Fourth resolution

The Meeting decides that the accounts and other documents of the Company will remain deposited for a period of

five years at the registered office of CF Corporate Services, and that all the sums and assets eventually belonging to
members and creditors who are not present at the end of the liquidation will be deposited at the same place for the
benefit of whom it may concern.

<i>Fifth resolution

The Meeting decides to grant full powers to the bearer of a certified copy of the present deed in view of the final

settlement of the Company's accounts and of the fulfilment of all formalities.

Nothing else being on the agenda, the meeting is closed.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are

estimated at EUR 1,100.-.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their surname, first name, civil

status and residence, they signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le vingt-cinq avril.
Par devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg, sous-

signée.

Se réunit

l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société HAMPSHIRE S.A., une société anonyme en liqui-

dation ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, constituée en date du 19 avril 2005
suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire alors de résidence à Mersch, publié au Mémorial C, Recueil des

81069

L

U X E M B O U R G

Sociétés et Associations numéro 844 du 5 septembre 2005, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Lu-
xembourg, à la section B, sous le numéro 107411.

La Société a été mise en liquidation suivant acte du notaire soussigné en date du 10 décembre 2013, comprenant

nomination de CF Corporate Services, Luxembourg, en tant que liquidateur.

AUDIEX S.A., ayant son siège social au 9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg, a été nommée commissaire de

contrôle à la liquidation par acte sous seing privé en date du 2 avril 2014.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Luc HANSEN, licencié en administration des affaires, avec

adresse professionnelle au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Le Président nomme comme secrétaire Madame Carine GRUNDHEBER, employée privée, avec adresse profession-

nelle au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Marc ALBERTUS, employé privé, avec adresse professionnelle au 2,

avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée ayant ainsi été constitué, le Président déclare et requiert au notaire d'acter que:
I) L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1. Présentation du rapport du commissaire de contrôle.
2. Décharge aux administrateurs, au commissaire aux comptes, au liquidateur et au commissaire de contrôle pour

l'exécution de leurs mandats respectifs.

3. Clôture de la liquidation.
4. Décision quant au lieu de dépôt et de conservation des registres et documents de la société pendant la période

légale de cinq ans.

5. Mandat à confier en vue de clôturer les comptes de la société et d'accomplir toutes les formalités.
II) Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils

détiennent sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires des
actionnaires représentés, par les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentaire, restera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instru-

mentaire, resteront aussi annexées au présent acte.

III) Il appert de la liste de présence que les 1.200 (mille deux cents) actions, représentant l'intégralité du capital social,

sont présentes ou dûment représentées à la présente Assemblée Générale Extraordinaire.

IV) Le Président constate que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur

tous les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'Assemblée cette dernière prend à l'unanimité des voix les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire de contrôle à la liquidation, approuve ledit

rapport ainsi que les comptes de liquidation.

Le rapport du commissaire de contrôle à la liquidation, après avoir été signé «ne varietur» par les membres du bureau

et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée donne décharge pleine et entière aux administrateurs, au commissaire aux comptes, au liquidateur et au

commissaire de contrôle à la liquidation pour l'exercice de leurs mandats respectifs.

<i>Troisième résolution

L'Assemblée prononce la clôture de la liquidation de la Société.

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans au

siège de CF Corporate Services et, en outre, que les sommes et valeurs éventuelles revenant aux associés ou aux créan-
ciers qui ne se seraient pas présentés à la clôture de la liquidation seront déposés au même endroit au profit de qui il
appartiendra.

<i>Cinquième résolution

L'Assemblée décide de conférer tous pouvoirs au porteur d'une expédition du présent acte en vue de clôturer les

comptes de la Société et d'accomplir toutes les formalités.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

81070

L

U X E M B O U R G

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société en raison du

présent acte sont évalués à environ EUR 1.100,-.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate qu'à la demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ils ont signé avec

Nous notaire le présent acte.

Signé: L. HANSEN, C. GRUNDHEBER, M. ALBERTUS, C. DELVAUX.
Enregistré à Redange/Attert, le 28 avril 2014. Relation: RED/2014/954. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): T. KIRSCH.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Redange-sur-Attert, le 28 avril 2014.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2014059259/152.
(140068584) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2014.

M.U.H. LUXEMBURG G.m.b.H., Milch-Union Hocheifel Luxemburg G.m.b.H., Société à responsabilité

limitée.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 2, am Hock.

R.C.S. Luxembourg B 101.181.

Im Jahre zweitausendvierzehn, den neunten April.
Vor dem unterzeichneten Notar Pierre PROBST, mit dem Amtssitz zu Ettelbruck.

Ist erschienen:

Die Gesellschaft deutschen Rechts Arla Foods Deutschland GmbH, mit Sitz in D-40472 Düsseldorf, Wahlerstrasse 2,

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf, unter der Nummer HRB 68517,

hier vertreten durch einen Geschäftsführer und zwar Herrn Morten Nicolaj ROSE-NIELSEN, geboren in Lausanne

(CH) am 14. November 1970, wohnhaft in DK-7120 Veijle Øst, Højstrupvej 37, und einem Prokuristen, Herrn Klaus
Herbert BECKER, geboren am 7. März 1969 in Ehrang, jetzt Trier (D), wohnhaft in D-54494 Maring-Noviand, In der Duhr
15,

hier vertreten durch
Herrn Christoph FANK, Privatbeamter, beruflich wohnhaft in L-9991 Weiswampach, Gruus-Strooss 61;
auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift vom 1. April 2014,
welche Vollmacht, nach gehöriger "ne varietur" Paraphierung durch den Bevollmächtigten und dem amtierenden Notar,

gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigebogen bleibt um mit derselben einregistriert zu werden.

welche Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, dem unterzeichneten Notar erklärte, dass sie die alleinige Teilhaberin

ist  der  Gesellschaft  mit  beschränkter  Haftung  MILCH-UNION  HOCHEIFEL  LUXEMBURG  G.m.b.H.,  in  Abkürzung
M.U.H. LUXEMBURG G.m.b.H. ist, mit Sitz in L-9166 Mertzig, 4, Zone Industrielle, eingetragen im Handels- und Fir-
menregister Luxemburg, unter der Nummer B 101.181 (NIN 1993 2409 421);

Dass besagte Gesellschaft gegründet wurde gemäß Urkunde aufgenommen durch den Notar Henri Beck, mit Amtssitz

in Echternach, am 15. Oktober 1993, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 587
vom 9. Dezember 1993, und deren Statuten abgeändert wurden wie folgt:

- zufolge Urkunde aufgenommen durch denselben Notar am 30. März 2001, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations Nummer 966, vom 6. November 2001;

- zufolge Urkunde aufgenommen durch denselben Notar am 6. Juli 2004, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations Nummer 909, vom 11. September 2004;

- zufolge Urkunde aufgenommen durch denselben Notar am 12. Mai 2006, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations Nummer 1410, vom 21. Juli 2006.

- zufolge Urkunde aufgenommen durch denselben Notar am 25. Januar 2013, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil

des Sociétés et Associations Nummer 698, vom 21. März 2013.

B. Alsdann erklärt die Komparentin sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung einzufinden, zu welcher sie

sich als ordentlich einberufen betrachtet und folgendes beschließt:

81071

L

U X E M B O U R G

1.- Verlegung des Gesellschaftssitzes nach L-9991 Weiswampach, Am Hock 2;
2.- Infolgedessen Abänderung des ersten Absatzes von Artikel 3 der Satzung wie folgt:

„ Art. 3. (erster Absatz). Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Weiswampach.“
3. Erweiterung von Artikel 10 der Satzungen um folgenden Paragraphen:
„Der/die Geschäftsführer können die Ausschüttung von Zwischendividenden beschließen, unter Berücksichtigung der

diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.“

Da nichts weiter auf der Tagesordnung steht ist die Versammlung geschlossen.

<i>Erklärung des Unterzeichners

Der Gesellschafter erklärt hiermit, dass er der dinglich Begünstigte der Gesellschaft, die Gegenstand dieser Urkunde

ist, im Sinne des Gesetzes vom 12. November 2004 in der abgeänderten Fassung, und bescheinigt, dass die Mittel / Güter /
Rechte die das Kapital der Gesellschaft bilden nicht von irgendeiner Tätigkeit, die nach Artikel 506-1 des Strafgesetzbuches
oder Artikel 8-1 des Gesetzes vom 19. Februar 1973 betreffend den Handel von Arzneimitteln und die Bekämpfung der
Drogenabhängigkeit oder einer terroristische Handlung stammen im Sinne des Artikels 135-5 des Strafgesetzbuches (als
Finanzierung des Terrorismus definiert).

<i>Kosten und Honorare.

Die Kosten und Honorare der gegenwärtigen Urkunde sind zu Lasten der Gesellschaft und werden abgeschätzt auf

750.-€.

Worüber Urkunde, Aufgenommen in Ettelbruck, in der Amtsstube des amtierenden Notars, Datum wie eingangs

erwähnt.

Und nach Vorlesung an die Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vor-

namen,  sowie  Stand  und  Wohnort  bekannt,  hat  dieselbe  mit  dem  unterzeichnenden  Notar  gegenwärtige  Urkunde
unterschrieben.

Gezeichnet: Christoph FANK, Pierre PROBST.
Enregistré à Diekirch, le 10 avril 2014. Relation: DIE/2014/4646. Reçu soixante-quinze euros 75,00.-€.

<i>Le Receveur pd (signé): Recken.

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Begehr und zum Zwecke der Veröffentlichung im

Memorial erteilt.

Ettelbrück, den 28. April 2014.

Référence de publication: 2014059408/67.
(140068394) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2014.

Universe, The CMI Global Network Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2412 Luxembourg, 36, Rangwee.

R.C.S. Luxembourg B 33.463.

Les comptes annuels au 30.09.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 25.04.2014.

Référence de publication: 2014059584/10.
(140068137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2014.

Vitreclean-Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 20, rue Astrid.

R.C.S. Luxembourg B 98.701.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour Vitreclean-Services S.à r.l.
Fideco S.A.

Référence de publication: 2014059595/12.
(140068062) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2014.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

81072


Document Outline

Banque Havilland S.A.

Barbara International S.A.

Batiplan

Bativia.Lux

Cafe L'Italiano Vero S.à r.l.

Cortland Holdings S.à.r.l.

Digital Services XVII (GP) S.à r.l.

Digital Services XVIII S.à r.l.

Do Way S.à r.l.

Electrical Components International S.à r.l.

Hampshire S.A.

Milch-Union Hocheifel Luxemburg G.m.b.H.

Orco Germany S.A.

Safindi Re S.A.

SAS Institute S.à r.l.

Schorndorf Investments S.A.

SHCO 20 S.à r.l.

SHL Luxembourg S.à r.l.

Solicom S.A.

Somak (Europe) S.A.

Sopartag S.A.

Survicam S.à r.l.

Taurus Euro Retail Finance S.à r.l.

Taurus Euro Retail Holding S.à r.l.

Technique Ibérie S.à r.l.

Technovaa Holdings S.A.

Tersicore Invest S.A.

Tetragono S.A.

T-I-Q s.à r.l.

Top Auto S.à r.l.

Universe, The CMI Global Network Fund

V2 Architecture s.à r.l.

Valoneo Europe

Vitreclean-Services S.à r.l.

Vitreclean-Services S.à r.l.

Vitreclean-Services S.à r.l.

V Telecom Investment General Partner SA

W.BNK AG

Whitehall European RE 3 S.à r.l.

Whitehall European RE 4 S.à r.l.

Whitehall European RE 5 S.à r.l.

Whitehall European RE 6 S.à r.l.

Winland International Petroleum S.à r.l.