logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1594

20 juin 2014

SOMMAIRE

ACRON Wien West A3 S.A.  . . . . . . . . . . . .

76489

Actavis Funding SCS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76480

Actavis Funding SCS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76481

Dolphimmo Investments S.A.  . . . . . . . . . . .

76467

EIM Participations Luxembourg S.A.  . . . .

76474

FM Racing S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76467

France Properties Invest S.A.  . . . . . . . . . . .

76468

Gamax Management AG  . . . . . . . . . . . . . . .

76482

Genesta Nordic Capital Fund Management

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76502

Genesta Property Nordic Luxembourg

Sarl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76502

G.O. IA - Luxembourg One S.à r.l. . . . . . . .

76468

Hosta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76468

Hubis S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76468

IFS Capital Luxemburg II S.A. . . . . . . . . . . .

76469

Inolux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76472

Inspiration Concept Lux S.à r.l. . . . . . . . . . .

76470

Inspiration Concept Lux S.à r.l. . . . . . . . . . .

76470

Iris Participations S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76474

IVG Praterstrasse Immobilien GmbH . . . .

76469

Jardines Inmo S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76471

Jocan S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76471

KLP Real Estate Queen Anne's Chambers

S.à.r.l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76470

Koma Services Corporation . . . . . . . . . . . . .

76474

KoMed Home Care S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

76474

Lehwood Holdings S.à. r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

76466

Lepus Holdings (Lux) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

76466

Liberfy S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76466

Lilas Securities Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76466

Lion/Gem Luxembourg 3 S.à r.l. . . . . . . . . .

76512

Logiparts S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76467

Logiparts S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76473

Lux-Impact S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76473

Magellan Profit Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

76466

Minhal France S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76468

Mobile Telesystems Finance S.A.  . . . . . . . .

76470

Moussepage S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76467

Musca S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76472

Nascar Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76471

N.M.A. Benelux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76470

N.M.A. Benelux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76471

N.M.A. Benelux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76470

N.M.A. Benelux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76471

Panda TMT Investments S.à r.l.  . . . . . . . . .

76472

Petit Castelet S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76474

PG Investments International S.A. . . . . . . .

76508

Property Trust Kali, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

76473

P.S.M. Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

76473

Real Marku Lux Estates Sàrl  . . . . . . . . . . . .

76512

Santander SICAV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76501

Sendosa S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76485

Swedbank Robur International  . . . . . . . . . .

76499

Thorp S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76504

T. Rowe Price Funds Sicav  . . . . . . . . . . . . . .

76492

WealthCap S.A. SICAV-SIF  . . . . . . . . . . . . .

76485

76465

L

U X E M B O U R G

Lehwood Holdings S.à. r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.525,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 109.957.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 avril 2014.

Référence de publication: 2014056054/10.
(140064168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2014.

Lepus Holdings (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 136.528.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 avril 2014.

Référence de publication: 2014056055/10.
(140064378) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2014.

Lilas Securities Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 105.767.

Les comptes annuels, les comptes de Profits et Pertes ainsi que les Annexes de l'exercice clôturant au 31/12/2013 ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>L'Organe de Gestion

Référence de publication: 2014056056/11.
(140064411) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2014.

Liberfy S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 110.851.

Statuts coordonnés, suite à l’assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de rési-

dence à Esch/Alzette, en date du 30 octobre 2013 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 2 décembre 2013.

Référence de publication: 2014056063/11.
(140064713) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2014.

Magellan Profit Invest S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 132.345.

EXTRAIT

Le siège social de la société MAGELLAN PROFIT INVEST S.A., immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés

sous  le  numéro  B  132345,  dont  le  siège  social  fixé  au  L-1251  Luxembourg,  13,  avenue  du  Bois,  est  dénoncé  par  le
domiciliataire avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SOCIETE DE GESTION FIDUCIAIRE S.à R.L.

Référence de publication: 2014056090/12.
(140064110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2014.

76466

L

U X E M B O U R G

Logiparts S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.

R.C.S. Luxembourg B 44.637.

Le bilan au 31/12/2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014056071/10.
(140064424) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2014.

Dolphimmo Investments S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 143.231.

La convention de domiciliation conclue entre TRUSTCONSULT LUXEMBOURG S.A., 127 rue de Mühlenbach, L-2168

Luxembourg, et la société DOLPHIMMO INVESTMENTS S.A., société anonyme, enregistrée au registre de commerce
de Luxembourg sous le numéro RCS B 143231, a été dénoncée avec effet immédiat par le domiciliataire en date du 26
mars 2014; le siège de la société est ainsi dénoncé.

Trustconsult Luxembourg S.A.
Signature
<i>Le Domiciliataire

Référence de publication: 2014055931/13.
(140064134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2014.

FM Racing S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 139.589.

EXTRAIT

Il résulte des décisions prises par l'actionnaire unique de la Société en date du 18 avril 2014 que les mandats des

personnes suivantes ont été renouvelés et ce jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes clos au
31 décembre 2018:

- Monsieur Claudio MASSA, en tant qu'administrateur de catégorie A et Président du Conseil d'Administration;
- Sandrine BISARO, en tant qu'administrateur de catégorie B;
- Monsieur Patrick MOINET, en tant qu'administrateur de catégorie B; et
- Révisoncult S.à.r. l., en tant que commissaire.
De plus, la Société prend acte des changements d'adresse ci-dessous:
- Sandrine BISARO au 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg;
- Patrick MOINET au 156, rue Albert Unden, L-2652 Luxembourg;
- REVICONSULT S.à r.l. au 24 Avenue Victor Hugo L-1750 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme

Luxembourg, le 18 avril 2014.

Référence de publication: 2014055968/22.
(140064696) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2014.

Moussepage S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 14-16, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 143.576.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014056089/9.
(140064659) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2014.

76467

L

U X E M B O U R G

France Properties Invest S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 148.303.

Le bilan au 31/12/2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9/4/2014.

Signature.

Référence de publication: 2014055971/10.
(140064201) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2014.

G.O. IA - Luxembourg One S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.230.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 96.564.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 avril 2014.

Référence de publication: 2014055979/10.
(140064103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2014.

Hosta, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 177.844.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 avril 2014.

Référence de publication: 2014055996/10.
(140064529) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2014.

Hubis S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5426 Greiveldange, 12A, A Benzelt.

R.C.S. Luxembourg B 72.936.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2014056008/11.
(140064148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2014.

Minhal France S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 62.000,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 154.766.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 avril 2014.

Luxembourg Corporation Company S.A.
Signatures
<i>Mandataire

Référence de publication: 2014056084/13.
(140064221) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2014.

76468

L

U X E M B O U R G

IFS Capital Luxemburg II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 159.175.

<i>Extrait des décisions prises par le conseil d'administration et par l'assemblée générale des actionnaires en date du 2 avril 2014

1. Le siège social a été transféré de L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, à L-2453 Lu-

xembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

2. Monsieur Roeland DE GRAAF, administrateur de sociétés, né à Hilversum (Pays-Bas), le 23 décembre 1985, de-

meurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommé comme administrateur jusqu'à
l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2015.

3. Le nombre des administrateurs a été augmenté de trois à quatre.
Veuillez noter que l'adresse professionnelle de Madame Monique JUNCKER et Monsieur Hans DE GRAAF, adminis-

trateurs,  et  de  Madame  Ingrid  CERNICCHI,  administrateur  et  de  présidente  du  conseil  d'administration,  se  situe
désormais au L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

Luxembourg, le 18 avril 2014.

Pour extrait et avis sincères et conformes
<i>Pour IFS Capital Luxemburg II S.A.
Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2014056017/21.
(140064719) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2014.

IVG Praterstrasse Immobilien GmbH, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.600,00.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 24, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 146.725.

<i>Auszug aus der schriftlichen Beschlussfassung des alleinigen Gesellschafters der Gesellschaft vom 14. März 2014

Am 14. März 2014 hat der alleinige Gesellschafter der Gesellschaft folgenden Beschluss gefasst:
- Abberufung von Herrn Osman Saritarla als Geschäftsführer der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung;
- Ernennung von Frau Irmgard Linker, geboren am 29. August 1968 in Friedberg, Deutschland, mit beruflicher Adresse

in: The Squaire 18, Am Flughafen, 60549 Frankfurt/Main, Deutschland, als Geschäftsführern der Gesellschaft mit sofortiger
Wirkung und dies für eine unbestimmte Zeit;

- Ernennung von Herrn Jan Kuhn, geboren am 27. Juli 1976 in Bonn, Deutschland, geschäftsansässig in THE SQUAIRE

18, Am Flughafen, D-60549 Frankfurt am Main, Deutschland, als Geschäftsführer der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung
und dies für eine unbestimmte Zeit;

- Ernennung von Herrn Cyril Amos Schelling, geboren am 20. Mai 1980 in St. Quentin, Frankreich, geschäftsansässig

in 24, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, als Geschäftsführer der Gesellschaft mit
sofortiger Wirkung und dies für eine unbestimmte Zeit;

- Ernennung von Herrn Dr. Matthias Eder, geboren am 30. November 1976 in Würzburg, Deutschland, geschäftsan-

sässig in 24, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, als Geschäftsführer der Gesellschaft
mit sofortiger Wirkung und dies für eine unbestimmte Zeit.

Infolge der vorliegenden Beschlüsse wird sich der Geschäftsführerrat der Gesellschaft fortan wie folgt zusammensetzen:
- Herr Dr. Matthias Eder,
- Herr Jan Kuhn;
- Frau Irmgard Linker;
- Herr Andréas Rosenberger; und
- Herr Cyril Amos Schelling.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 16. April 2014.

IVG Luxembourg S.à r.l.
Unterschrift

Référence de publication: 2014056031/33.
(140064220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2014.

76469

L

U X E M B O U R G

Inspiration Concept Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1249 Luxembourg, 3-11, rue du Fort Bourbon.

R.C.S. Luxembourg B 134.773.

Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014056021/10.
(140064539) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2014.

Inspiration Concept Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1249 Luxembourg, 3-11, rue du Fort Bourbon.

R.C.S. Luxembourg B 134.773.

Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014056022/10.
(140064540) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2014.

Mobile Telesystems Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 11-13, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 84.895.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour MOBILE TELESYSTEMS FINANCE S.A.
Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2014056095/11.
(140064625) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2014.

N.M.A. Benelux S.A., Société Anonyme,

(anc. N.M.A. Benelux).

Siège social: L-2561 Luxembourg, 7, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 158.168.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait sincère conforme
NMA BENELUX S.A.
Signature

Référence de publication: 2014056100/12.
(140064542) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2014.

KLP Real Estate Queen Anne's Chambers S.à.r.l, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 180.973.

Statuts coordonnés, suite à l’assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de rési-

dence à Esch/Alzette, en date du 30 octobre 2013 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 6 décembre 2013.

Référence de publication: 2014056044/11.
(140064703) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2014.

76470

L

U X E M B O U R G

Jocan S.à r.l., Société à responsabilité limitée soparfi.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 21.110.

<i>Extrait des décisions prises par le conseil de gérance et par l'associée unique en date du 2 avril 2014

1. Le siège social a été transféré de L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, à L-2453 Lu-

xembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

2. Monsieur Roeland DE GRAAF, administrateur de sociétés, né à Hilversum (Pays-Bas), le 23 décembre 1985, de-

meurant  professionnellement  à  L-2453  Luxembourg,  6,  rue  Eugène  Ruppert,  a  été  nommé  gérant  pour  une  durée
indéterminée.

3. Le nombre de gérants a été augmenté de deux à trois.
Veuillez noter que l'adresse professionnelle de Madame Monique JUNCKER et Monsieur Hans DE GRAAF, gérants,

se situe désormais au L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

Luxembourg, le 18 avril 2014.

Pour extrait et avis sincères et conformes
<i>Pour JOCAN S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2014056037/20.
(140064639) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2014.

Jardines Inmo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 84.671.

Le Bilan au 31.12.2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8/4/2014.

Signature.

Référence de publication: 2014056034/10.
(140064199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2014.

N.M.A. Benelux S.A., Société Anonyme,

(anc. N.M.A. Benelux).

Siège social: L-5842 Hesperange, 1, Am Weischbaendchen.

R.C.S. Luxembourg B 158.168.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait sincère conforme
NMA BENELUX S.A.
Signature

Référence de publication: 2014056101/12.
(140064543) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2014.

Nascar Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 37.494.

Les comptes annuels au 30 juin 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

NASCAR FINANCE S.A.
Signatures
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2014056103/12.
(140064189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2014.

76471

L

U X E M B O U R G

Inolux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3871 Schifflange, 13, rue de la Paix.

R.C.S. Luxembourg B 170.120.

<i>Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de INOLUX S.A., tenue au siège social le 27 Mars 2014 à 09

<i>heures

<i>Résolutions

1. L'Assemblée approuve la radiation de l'Administrateur à savoir Monsieur Nicolas CORPS, ayant son adresse au 30,

rue Jeanne Jugan F-57070 Metz (FRANCE) suivant sa lettre de démission du 05 Novembre 2013.

2. L'Assemblée approuve la radiation de l'Administrateur-délégué à savoir Monsieur Nicolas CORPS, ayant son adresse

au 30, rue Jeanne Jugan F-57070 Metz (FRANCE) suivant sa lettre de démission du 05 Novembre 2013.

3. L'Assemblée approuve la radiation de l'Administrateur à savoir Monsieur Philippe HARY, ayant son adresse au 10,

rue du Bétiel F-57390 Audun-le-Tiche (FRANCE) suivant sa lettre de démission du 25 Mars 2014.

4. L'Assemblée approuve la nomination de l'Administrateur à savoir Monsieur Pascal VERGULDEZOONE, ayant son

adresse au 9D, rue Sainte Anne F-57330 Roussy-le-Village (FRANCE).

5. L'Assemblée approuve la nomination de l'Administrateur-Délégué à savoir Monsieur Pascal VERGULDEZOONE,

ayant son adresse au 9D, rue Sainte Anne F-57330 Roussy-le-Village (FRANCE).

Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels du 31 Décembre

2018.

Toutes les résolutions sont prises à l'unanimité des voix.
Tous les points de l'ordre du jour ayant été traités, la séance est levée à 10 heures après signature du présent procès-

verbal par les membres du bureau.

Daniel LOUIS / Stéphane LOCATELLI / Pascal VERGULDEZOONE
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

Référence de publication: 2014056019/27.
(140064709) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2014.

Musca S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2562 Luxembourg, 2, place de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 96.900.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires prise en date du 1 

<i>er

<i> mars 2014

<i>Première résolution

L'Assemblée décide à l'unanimité de renouveler le mandat de Commissaire aux comptes de:
I.C. DOM-COM Sàrl (anciennement ALTER DOM-COM Sàrl)
163, rue du Kiem
L-8030 Strassen, Luxembourg
Jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'année 2017.

<i>Pour MUSCA S.A.

Référence de publication: 2014056097/15.
(140064668) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2014.

Panda TMT Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 170.531.

Veuillez prendre note que la société à responsabilité limitée Intertrust (Luxembourg) S.à r.l, R.C.S. Luxembourg B

103.123, avec siège social à L-2453 Luxembourg, 6 rue Eugène Ruppert, a dénoncé le siège social de la société à respon-
sabilité limitée PANDA TMT INVESTMENTS S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 170.531 en date du 4 avril 2014.

Luxembourg, le 17 avril 2014.

Pour avis sincère et conforme
Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2014056114/12.
(140064417) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2014.

76472

L

U X E M B O U R G

Logiparts S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.

R.C.S. Luxembourg B 44.637.

Le bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Mandataire

Référence de publication: 2014056072/10.
(140064431) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2014.

Lux-Impact S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4170 Esch-sur-Alzette, 26-28, boulevard J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 146.372.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014056074/10.
(140064564) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2014.

P.S.M. Investment S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 36.307.

<i>Extrait des décisions prises par le conseil d'administration et par l'assemblée générale des actionnaires en date du 2 avril 2014

1. Le siège social a été transféré de L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, à L-2453 Lu-

xembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

2. Monsieur Roeland DE GRAAF, administrateur de sociétés, né à Hilversum (Pays-Bas), le 23 décembre 1985, de-

meurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommé comme administrateur jusqu'à
l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2016.

3. Le nombre des administrateurs a été augmenté de trois à quatre.
Veuillez noter que l'adresse professionnelle de Madame Monique JUNCKER et Madame Ingrid CERNICCHI, adminis-

trateurs, et de Monsieur Hans DE GRAAF, administrateur et de président du conseil d'administration, se situe désormais
au L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

Luxembourg, le 18 avril 2014.

Pour extrait et avis sincères et conformes
<i>Pour P.S.M. INVESTMENT S.A.
Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2014056112/21.
(140064688) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2014.

Property Trust Kali, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 120.369.

Les comptes annuels au 30 juin 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Property Trust Kali, S.à r.l.
SGG S.A.
Signatures
<i>Mandataire

Référence de publication: 2014056131/13.
(140064326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2014.

76473

L

U X E M B O U R G

Koma Services Corporation, Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 86.121.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg Corporation Company SA
Signatures

Référence de publication: 2014056045/11.
(140064567) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2014.

KoMed Home Care S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 40-42, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 62.470.

AUSZUG

Im Protokoll der Sitzung des Verwaltungsrates, die am 15. April 2014 abgehalten worden ist, haben die Verwaltungs-

ratsmitglieder folgende Entscheidungen getroffen:

a) Der Verwaltungsrat nimmt den Rücktritt von Herrn Klaus KREBS, geboren in Trier (Deutschland) am 14.07.1975,

wohnhaft in D-54294 Trier, Grimmestrasse 9, als Vorsitzender des Verwaltungsrates und Verwaltungsratsmitglied mit
sofortiger Wirkung zur Kenntnis.

b) Der Verwaltungsrat beschließt alle Prokuren und alle Bankvollmächte mit sofortiger Wirkung zu widerrufen und

dass  der  Geschäftsführer  Herrn  Hermann  Konrad,  geboren  in  Saarburg  (Deutschland)  am  14.01.1963,  wohnhaft  in
D-54459 Wiltingen, Klosterbergstrasse 127,  die  Gesellschaft rechtmäßig  mit  alleiniger Unterschrift zu vertreten  und
verpflichten.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 15. April 2014.

<i>Für den Verwaltungsrat

Référence de publication: 2014056040/20.
(140063785) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2014.

Petit Castelet S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 161.368.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014056119/10.
(140064648) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2014.

EIM Participations Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 52.297.

Iris Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 187.788.

L’an deux mille quatorze, le treize juin.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S’est réunie

une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de EIM PARTICIPATIONS LUXEMBOURG S.A., une société

anonyme, ayant son siège social au 10/B, rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange (la “Société”), immatriculée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (le “RCSL”) sous le numéro B 52.297, constituée suivant acte
reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Dudelange, en date du 12 septembre 1995, publié au Mémorial

76474

L

U X E M B O U R G

C, Recueil des Sociétés et Associations (le “Mémorial”) numéro 597 du 24 novembre 1995. Les statuts ont été modifiés
à plusieurs reprises dont la dernière fois par un acte du notaire instrumentaire, en date du 22 avril 2014, publié au Mémorial
numéro 1117 du 3 mai 2014.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Frédéric Lemoine, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Nathalie Englebert, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Raphaëlle Marcel, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que l’actionnaire représenté à l’assemblée et le nombre d’actions détenues par lui sont renseignés sur une liste de

présence, signée par le mandataire, le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. Ladite liste de
présence ainsi que la procuration, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumen-
taire resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu'il apparaît de la liste de présence que les quatre cent vingt-trois (423) actions représentant l’intégralité du capital

social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valable-
ment sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont l’actionnaire a été informé avant l’assemblée.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire est le suivant:
1. Approbation de la scission partielle de la Société, par constitution d’une nouvelle société, consistant en le transfert

d’une partie des actifs et passifs de la Société, sans dissolution de cette dernière, à une nouvelle société anonyme de droit
luxembourgeois (la “Nouvelle Société”), constituée par l’effet de la scission (la “Scission”), conformément au projet de
scission.

2. Approbation du transfert de l’ensemble des éléments du patrimoine actif et passif de la Société à la Nouvelle Société

de la façon indiquée dans le projet de scission publié conformément aux Articles 9 et 290 de la loi sur les sociétés
commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée (la “LSC”), le tout sur le vu du rapport d’un réviseur d’entreprises
agréé en application de l’Article 26-1 de la LSC.

3. Décision de réduire le capital social de la Société d’un montant de cent cinquante et un mille Dollars US (151.000

USD) afin de le porter de son montant actuel de quatre cent vingt-trois mille Dollars US (423.000 USD) à deux cent
soixante-douze mille Dollars US (272.000 USD), en conséquence du transfert d’une partie des actifs et passifs de la Société
à la Nouvelle Société par voie de la Scission.

4. Modification subséquente du premier paragraphe de l’Article 5 des statuts de la Société afin de refléter la réduction

du capital social.

5. Nomination des organes sociaux et fixation de l’adresse du siège social de la Nouvelle Société.
6. Prise d’effet de la Scission.
IV.- Les dispositions de la LSC relatives aux scissions ont été respectées comme suit:
1. Le projet de scission tel qu'établi par le conseil d’administration de la Société et tel que signé le 7 mai 2014, a été

déposé auprès du RCSL et a été publié au Mémorial le 12 mai 2014, soit au moins un (1) mois avant la date de cet acte.

2. Les documents exigés par l’Article 295 de la LSC, ont été déposés au siège social de la Société, en vue de leur

consultation par l’actionnaire, au moins un (1) mois avant la date de cet acte. Une attestation de la Société certifiant la
disponibilité de ces documents, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire,
restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

V.- Par conséquent, l’assemblée générale a décidé à l’unanimité ce qui suit:

<i>Première résolution

L’assemblée, après avoir revu le projet de scission daté du 7 mai 2014, a décidé d’approuver la Scission telle qu'envisagée

par le projet de scission.

L’assemblée a décidé ainsi de constater sous forme authentique les statuts de «IRIS PARTICIPATIONS S.A.», la Nou-

velle Société, tels que repris dans le projet de scission, à savoir:

«Titre I 

er

 . - Forme - Dénomination - Siège social - Objet - Durée

Art. 1 

er

 . Forme.  Il existe une société anonyme (la «Société»), qui sera régie par les lois relatives à une telle entité,

et en particulier par la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée de temps à autre (la
«Loi»), ainsi que par les présents statuts (les «Statuts»).

Art. 2. Dénomination. La dénomination de la Société est «IRIS PARTICIPATIONS S.A.».

Art. 3. Siège social.
3.1. Le siège de la Société est établi dans la commune de Bertrange.
3.2. Il peut être transféré en toute autre localité à l’intérieur du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l’as-

semblée générale des Actionnaires (tel que défini ci-après) délibérant comme en matière de modification des Statuts.

3.3. Le siège social peut être transféré à l’intérieur de la commune de Bertrange par simple décision de l’Administrateur

Unique ou, en cas de pluralité d’administrateurs, du Conseil d’Administration (tels que définis ci-après).

76475

L

U X E M B O U R G

3.4. Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se sont produits ou sont
imminents, le siège social peut être transféré provisoirement à l’étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances
anormales. Une telle décision n’aura cependant aucun effet sur la nationalité de la Société. Pareille déclaration de transfert
du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la Société qui est le mieux placé pour le faire dans
ces circonstances.

3.5. L’Administrateur Unique ou, en cas de pluralité d’administrateurs, le Conseil d’Administration peut constituer des

succursales ou des bureaux de représentation tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l’étranger.

Art. 4. Objet.
4.1. L’objet de la Société est l’acquisition et la détention de tous intérêts, directement ou indirectement, sous quelle

que forme que ce soit, dans toutes autres entités, luxembourgeoises ou étrangères, par voie, entre autres, de souscription
ou d’acquisition de toutes participations et droits par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou
d’option d’achat, de négociation ou de toute autre manière, ou par voie d’instruments financiers de dettes, sous quelle
que forme que ce soit, ainsi que leur administration, leur développement et leur gestion.

4.2. La Société pourra également apporter toute assistance financière, que ce soit sous forme de prêts, d’octroi de

garanties ou autrement, à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, sans que celui-ci
soit substantiel, ou à toutes sociétés, qui seraient actionnaires, directs ou indirects, de la Société, ou encore à toutes
sociétés appartenant au même groupe que la Société (les “Sociétés Apparentées”). A titre accessoire de cette assistance
financière, la Société pourra également apporter à ses Sociétés Apparentées toute assistance administrative et commer-
ciale.

4.3. Pour les besoins de cet article, une société sera considérée comme appartenant au même «groupe» que la Société

si cette autre société, directement ou indirectement, détient, est détenue par, détient le contrôle de, est contrôlée par
ou est sous le contrôle commun avec, ou est contrôlée par un actionnaire de la Société, que ce soit comme bénéficiaire,
trustee ou gardien ou autre fiduciaire. Une société sera considérée comme contrôlant une autre société si elle détient,
directement ou indirectement, tout ou une partie substantielle de l’ensemble du capital social de la société ou dispose
du pouvoir de diriger ou d’orienter la gestion et les politiques de l’autre société, que ce soit aux moyens de la détention
de titres permettant d’exercer un droit de vote, par contrat ou autrement.

4.4. La Société pourra, en particulier, être engagée dans les opérations suivantes:
4.4.1. conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de crédit et lever des fonds, notamment, par

l’émission de titres, d’obligations, de billets à ordre, certificats et autres instruments de dettes, convertibles ou non, ou
par l’utilisation d’instruments financiers dérivés ou autres;

4.4.2. accorder toute garantie, fournir tout gage ou toute autre forme de sûreté, que ce soit par engagement personnel

ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par toutes ou l’une de ces méthodes,
pour l’exécution de tous contrats ou obligations de la Société et de toute Société Apparentée, ou de tout administrateur,
gérant ou autre agent de la Société ou de l’une des Sociétés Apparentées, dans les limites de toute disposition légale
applicable; et

4.4.3. utiliser tous instruments et techniques nécessaires à la gestion efficace de ses investissements et à la protection

contre tous risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d’intérêt et autres risques.

Etant entendu que la Société n’entrera dans aucune opération qui pourrait l’amener à être engagée dans des activités

pouvant être considérées comme une activité réglementée du secteur financier.

4.5. Outre ce qui précède, la Société peut réaliser toutes transactions juridiques, commerciales, techniques ou finan-

cières et en général toutes transactions nécessaires ou utiles à l’accomplissement de son objet social ou en relation directe
ou indirecte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à faciliter l’accomplissement de son objet social dans les secteurs
prédécrits.

Art. 5. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Titre II. - Capital - Actions

Art. 6. Capital.
6.1. Le capital social de la Société est fixé à cent cinquante et un mille Dollars US (151.000 USD) représenté par cent

cinquante et une (151) actions d’une valeur nominale de mille Dollars US (1.000 USD) chacune (les «Actions»). Les
détenteurs des Actions sont désignés collectivement comme les «Actionnaires».

6.2. En plus du capital social, il pourra être établi un compte de prime d’émission sur lequel toute prime d’émission

payée pour toute Action sera versée. Le montant d’un tel compte de prime d’émission est à la libre disposition de
l’assemblée générale des Actionnaires. Le montant d’un tel compte de prime d’émission peut être utilisé pour procéder
à des paiements pour toutes Actions que la Société peut racheter à son/ses Actionnaire(s), pour compenser toute perte
réalisée, pour procéder à des distributions à l’/aux Actionnaire(s) ou pour allouer des fonds à la réserve légale ou à
d’autres réserves.

76476

L

U X E M B O U R G

Art. 7. Actions.
7.1. Chaque Action donne droit à une voix. Les Actions peuvent être représentées, au choix du propriétaire, par des

certificats représentant une Action ou des certificats représentant deux ou plusieurs Actions.

7.2. Les Actions sont soit nominatives, soit au porteur, au choix de l’Actionnaire.
7.3. La Société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la Loi le permet, procéder au rachat de ses propres

Actions.

7.4. Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III. - Administration

Art. 8. Administration.
8.1. La Société peut être administrée par un administrateur unique (l’ «Administrateur Unique»), Actionnaire ou non,

aussi longtemps qu’il y a un Actionnaire unique. Au cas où il y a plusieurs Actionnaires, la Société sera administrée par
un conseil d’administration composé de trois (3) membres au moins, Actionnaires ou non (le «Conseil d’Administration
et chaque membre individuellement, un Administrateur»). Les Administrateurs sont nommés par l’assemblée générale
des Actionnaires, pour un terme ne pouvant dépasser six (6) années et en tout temps révocables par elle.

8.2. Le nombre d’Administrateurs, la durée de leur mandat et leurs émoluments sont fixés par l’assemblée générale

des Actionnaires.

Art. 9. Réunion du conseil d’administration.
9.1. Le Conseil d’Administration choisira un président parmi ses membres.
9.2. Le Conseil d’Administration se réunit sur convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux Administrateurs le demandent. Lorsque tous les Administrateurs sont présents
ou représentés, ils peuvent renoncer aux formalités et conditions de convocation.

9.3. Chaque Administrateur peut agir à toute réunion du Conseil d’Administration en désignant par écrit, par télé-

gramme, par fax, courriel ou lettre, un autre Administrateur comme son mandataire.

9.4.  Les  réunions  du  Conseil  d’Administration  se  tiendront  au  Luxembourg.  Le  Conseil  d’Administration  ne  peut

délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins de ses membres est présent en personne ou par mandataire.
Les résolutions seront valablement adoptées par la majorité des votes des Administrateurs présents en personne ou par
mandataire à telle réunion.

9.5. Tout membre du Conseil d’Administration qui participe à une réunion du Conseil d’Administration via un moyen

de communication (en ce compris par téléphone et par visio conférence) qui permet aux autres membres du Conseil
d’Administration présents à cette réunion (soit en personne soit par mandataire ou par un tel moyen de communication)
d’entendre et d’être entendus par les autres membres sera réputé présent à telle réunion et sera pris en compte pour
le calcul du quorum et autorisé à voter sur les matières traitées à telle réunion. Lorsque la décision est prise par voie
d’une conférence téléphonique, la décision sera considérée comme ayant été prise au Luxembourg si l’appel est initié à
partir du Grand-Duché de Luxembourg.

Les membres du Conseil d’Administration qui participent à une réunion du Conseil d’Administration via un tel moyen

de communication ratifieront leurs votes exprimés de cette façon en signant une copie du procès-verbal de la réunion.

9.6. En cas d’urgence, des résolutions écrites signées par tous les membres du Conseil d’Administration auront la

même validité et le même effet que des décisions prises lors d’une réunion valablement convoquée et tenue. Ces signatures
pourront être apposées sur un seul ou plusieurs documents séparés transmis par lettre, fax, courriel ou moyen similaire
de communication.

9.7. Le procès-verbal d’une réunion du Conseil d’Administration est signé par tous les Administrateurs présents ou

représentés à la réunion. Des extraits seront certifiés par le président ou tout Administrateur ou par toute personne
désignée lors d’une réunion du Conseil d’Administration.

9.8. En cas d’Administrateur Unique, les résolutions de l’Administrateur Unique seront documentées par écrit.

Art. 10. Pouvoirs.
10.1. L’Administrateur Unique ou, en cas de pluralité d’Administrateurs, le Conseil d’Administration est investi des

pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration et de disposition conformément à l’objet social de la
Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la Loi ou par les Statuts à l’assemblée générale des
Actionnaires sont de la compétence de l’Administrateur Unique ou, le cas échéant, du Conseil d’Administration.

10.2. La Société sera engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de son Administrateur Unique ou,

en cas de pluralité d’Administrateurs, par la signature conjointe de deux Administrateurs, à moins que des décisions
spéciales concernant la signature autorisée en cas de délégation de pouvoirs n’aient été prises par l’Administrateur Unique
ou, suivant le cas, le Conseil d’Administration conformément à l’article 11 des Statuts.

10.3. Tous litiges dans lesquels la Société est impliquée comme demandeur ou comme défendeur, seront traités au

nom de la Société par l’Administrateur Unique ou par le Conseil d’Administration, représenté par son président ou par
l’Administrateur délégué à cet effet.

76477

L

U X E M B O U R G

10.4. L’Administrateur Unique ou, en cas de pluralité d’Administrateurs, le Conseil d’Administration est autorisé à

payer des acomptes sur dividendes en respectant les dispositions légales.

Art. 11. Délégations.
11.1. L’Administrateur Unique ou, suivant le cas, le Conseil d’Administration peut déléguer la gestion journalière de

la Société à une ou plusieurs personnes, Administrateurs ou non.

11.2. Il peut aussi confier la gestion d’une branche spéciale de la Société à un ou plusieurs directeurs, et donner des

pouvoirs spéciaux pour l’accomplissement de tâches précises à un ou plusieurs mandataires, choisis parmi ses propres
membres ou non, Actionnaires ou non.

Titre IV. - Surveillance

Art. 12. Surveillance. Sauf lorsqu'en vertu de la Loi les comptes annuels statutaires doivent être audités par un réviseur

d’entreprises agréé, les comptes annuels de la Société seront revus par un ou plusieurs commissaires (à moins qu'il n’en
soit décidé différemment par l’assemblée générale des Actionnaires) nommé(s) par l’assemblée générale des Actionnaires
qui fixe leur nombre et sa/leur rémunération, ainsi que la durée de son/leur mandat qui ne peut excéder six (6) années.

Titre V. - Assemblée générale des actionnaires

Art. 13. Pouvoirs - Tenue des assemblées générales.
13.1. L’Actionnaire unique exercera tous les pouvoirs conférés à l’assemblée générale des Actionnaires par la Section

IV § 5 de la Loi et ses décisions sont établies par écrit et enregistrées dans des procès-verbaux. Dans ce cas et lorsque
le terme Actionnaire unique n’est pas expressément mentionné dans les Statuts, une référence à l’assemblée générale
des Actionnaires utilisée dans les Statuts doit être lue comme une référence à l’Actionnaire unique.

13.2. S’il y a plus d’un Actionnaire, les décisions des Actionnaires seront prises en assemblée générale des Actionnaires.
13.3. Si tous les Actionnaires sont présents ou représentés et informés de l’ordre du jour de l’assemblée, ils peuvent

renoncer aux formalités de convocation et l’assemblée peut valablement être tenue sans avis préalable.

13.4. Les assemblées générales des Actionnaires se tiendront au Luxembourg. Tout Actionnaire peut par procuration

écrite, autoriser toute autre personne, qui n’a pas besoin d’être un Actionnaire, à le représenter à une assemblée générale
des Actionnaires et à voter en son nom et à sa place.

13.5. Tout Actionnaire peut participer à toute assemblée générale des Actionnaires par conférence téléphonique ou

vidéoconférence ou par tout moyen similaire de communication permettant à toutes les personnes participants à l’as-
semblée d’être identifiés et de s’entendre et de se parler. La participation à une assemblée par ce moyen est considérée
comme équivalent à une participation en personne à telle assemblée.

13.6. Sauf disposition contraires de la Loi ou des Statuts, les décisions de l’assemblée générale des Actionnaires sont

prises à la majorité simple des votes exprimés valablement à l’assemblée, quelle que soit la portion du capital social présent
ou représenté à telle assemblée. L’abstention et les votes nuls ne seront pas pris en compte.

13.7.  Sous  réserve  des  termes  et  conditions  prévus  par  la  Loi,  les  Statuts  peuvent  être  modifiés  par  décision  de

l’assemblée générale des Actionnaires prises à la majorité des deux tiers (2/3) des votes exprimés valablement à une
assemblée où au moins la moitié (1/2) du capital social de la Société est présent ou représenté lors d’une première
convocation. Lors d’une seconde convocation, la décision sera prise à la majorité des deux tiers (2/3) des votes exprimés
valablement à l’assemblée, quelle que soit la portion du capital présent ou représenté à l’assemblée. L’abstention et les
votes nuls ne seront pas pris en compte.

13.8. L’assemblée générale annuelle des Actionnaires se tiendra au siège social ou à tel autre endroit à l’intérieur de

la commune du siège social précisé dans la convocation le troisième mardi du mois de mai à 16 heures.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée générale annuelle des Actionnaires se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI. - Exercice social - Répartition des bénéfices

Art. 14. Exercice social. L’exercice social de la Société commence le premier janvier et finit le trente et un décembre

de chaque année.

Art. 15. Répartition des bénéfices. L’excédent favorable du bilan, après déduction de toutes les charges de la Société

et des amortissements, constitue le bénéfice net de la Société. Sur ce bénéfice cinq pour cent (5%) seront affectés à la
réserve légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque ladite réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social,
mais reprend son cours si, à un moment quelconque, pour une cause quelconque, ladite réserve tombe en dessous de
dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

Le solde du bénéfice est à la disposition de l’assemblée générale des Actionnaires.

Titre VII. - Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution et liquidation. La Société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale des Actionnaires.
Si la Société est dissoute, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales,

nommés par l’assemblée générale des Actionnaires, qui déterminera leurs pouvoirs et fixera leurs émoluments.

76478

L

U X E M B O U R G

Titre VIII. - Loi applicable

Art. 17. Loi applicable. Pour tous les points non réglés par les Statuts, il est fait référence à la Loi.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée a décidé que le capital social de «IRIS PARTICIPATIONS S.A.» fixé à un montant de cent cinquante et un

mille Dollars US (151.000 USD), sera libéré conformément au projet de scission par le transfert à la Nouvelle Société
d’une partie du patrimoine actif et passif de la Société.

Les actifs et passifs transférés figurent comme suit au bilan (en Dollars US) de la Société au 22 avril 2014:

ACTIF
Participations
Wheb Ventures Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

241.146 USD

EIM (GIBRALTAR) Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 923. 864 USD
EIM France SAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 504 200 USD
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.669.210 USD
PASSIF
Capital social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

151.000 USD

Prime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600.649 USD

Réserve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71.181 USD

Bénéfices non distribués . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.728.979 USD
Sub total fonds propres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.551.809 USD
Dette envers EIM France SAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

117.401 USD

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.669.210 USD

Conformément à l’Article 294 (3), un rapport d’évaluation a été établi en date du 3 juin 2014 sur base de l’Article 26-1

de la LSC par ACSe, Audit Conseil Services S.à r.l., réviseur d’entreprises agréé, ayant son siège social au 283, route
d’Arlon, L-8011 Strassen, lequel rapport a été signé ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire
et restera annexé au présent acte.

La conclusion du rapport est la suivante: Sur la base des travaux réalisés et décrits ci-avant, aucun fait n’a été porté à

notre attention qui nous permet de croire que la méthode d’évaluation utilisée pour valoriser les actifs et passifs transférés
soit inappropriée et que dès lors la valeur de ces actifs et passifs ne correspond pas au moins à la valeur des actions émises
en contrepartie et à la valeur des primes, réserve et résultats reportés y attachés.

Lors de la prise d’effet de la Scission, l’actionnaire unique de la Société recevra automatiquement les actions de la

Nouvelle Société.

L’inscription des actions de la Nouvelle Société en faveur de l’actionnaire unique de la Société se fera dans le registre

des actions nominatives de la Nouvelle Société.

<i>Troisième résolution

L’assemblée a décidé de réduire son capital social d’un montant de cent cinquante et un mille Dollars US (151.000

USD) afin de le porter de son montant actuel de quatre cent vingt-trois mille Dollars US (423.000 USD) à deux cent
soixante-douze mille Dollars US (272.000 USD). Ladite réduction a lieu en conséquence du transfert d’une partie des
actifs et passifs de la Société à la Nouvelle Société par voie de la Scission.

<i>Quatrième résolution

Conformément à la résolution qui précède, l’assemblée a décidé de modifier le premier paragraphe de l’Article 5 des

statuts de la Société afin de lui donner la teneur suivante:

« Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à deux cent soixante-douze mille Dollars US (272.000 USD) représenté par

deux cent soixante-douze (272) actions d’une valeur nominale de mille Dollars US (1.000 USD) chacune.»

<i>Cinquième résolution

Cette résolution est prise pour le compte de la Nouvelle Société par l’actionnaire unique:
1) Le nombre d’administrateurs est fixé à quatre (4).
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
- Madame Catherine DE WAELE, née le 25 avril 1966 à Charleroi (Belgique), demeurant professionnellement au 10/

B rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange;

- Monsieur Alexandre KEUSSEOGLOU, né le 25 novembre 1959 à Lausanne (Suisse), demeurant au 8 boulevard

Princesse Charlotte, MC-98000 Monaco;

- Monsieur Roland BIOLLAY, né le 15 septembre 1950 à Presinge (Suisse), demeurant au 7 rue de la Tour, CH-1263

Crassier; et

76479

L

U X E M B O U R G

- Monsieur Arpad BUSSON, né le 27 janvier 1963 à Boulogne-Billancourt (France), demeurant au 20 Gilston Road,

GB-SW109SR Londres.

Leur mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale annuelle à tenir en 2019.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
la société MARBLEDEAL LUXEMBOURG S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 10/B rue

des Mérovingiens, L-8070 Bertrange, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourgeois
sous le numéro B 145.419.

Son mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale annuelle à tenir en 2019.
4) L’adresse de la Nouvelle Société est fixée au 10/B rue des Mérovingiens à L-8070 Bertrange.

<i>Sixième résolution

L’assemblée a décidé d’acter que la Scission prendra effet entre la Société et la Nouvelle Société à la date de cet acte

et vis-à-vis des tiers à la date de publication, dans le Mémorial, du présent acte notarié approuvant la Scission.

<i>Déclaration

Conformément à l’Article 300 (2) de la LSC, le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié et atteste l’existence et la

légalité, en droit luxembourgeois, des actes et formalités incombant à la Société en vue de la réalisation de la Scission.

DONT acte, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Après lecture faite aux comparants, connus du notaire instrumentaire par nom, prénom, état civil et demeure, lesdits

comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Lemoine, Englebert, Marcel, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 16 juin 2014. Relation: EAC/2014/8281. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur ff.

 (signé): M. Halsdorf.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014083686/313.
(140099472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2014.

Actavis Funding SCS, Société en Commandite simple.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 187.310.

<i>Extrait rectificatif de l'extrait de l'acte constitutif déposé au RCS Luxembourg sous la référence L140089479

Il convient de rectifier l'objet social de la Société de l'extrait de l'acte constitutif de Actavis Funding SCS, déposé au

R.C.S. Luxembourg sous la référence L140089479.

L'objet social de la Société est le suivant:
Objet social.
L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou entre-

prises  sous  quelque  forme  que  ce  soit,  et  la  gestion  de  ces  participations.  La  Société  peut  notamment  acquérir  par
souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs mobilières et instru-
ments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion
et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille
de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

L'objet de la Société consiste également au financement de toutes les sociétés faisant partie du groupe auquel la Société

appartient.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, par voie de placement privé ou d'offre publique. Elle peut

procéder à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de tous types de titres et instruments de dette ou de capital. La
Société peut prêter des fonds, y compris notamment les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés affiliées ainsi
qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou
autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles
de tout autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne.

La Société peut employer tous les moyens légaux et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investisse-

ments et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et
autres risques.

La Société peut effectuer des transactions qui, directement ou indirectement, se rapportent à son objet social.

76480

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014080382/32.
(140095742) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2014.

Actavis Funding SCS, Société en Commandite simple.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 187.310.

<i>Extrait de l'acte constitutif du 28 mai 2014

Actavis International Holding S.à r.l., une société à responsabilité limitée luxembourgeoise, dont le siège social est

établi au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre
du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 172.484 (l'Associé Commandité),

A signé, le 28 mai 2014, l'acte constitutif (l'Acte) d'une société en commandite simple (la Société) dont est extrait ce

qui suit:

1. Forme. Il est établi une société en commandite simple qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg,

en particulier la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), et par ses statuts (les
Statuts).

2. Dénomination. La dénomination de la Société est Actavis Funding SCS.

3. Siège Social. Le siège social de la Société est établi au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché

de Luxembourg.

4. Objet social. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes

sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment
acquérir par souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation,
obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs mobilières
et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement,
à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un
portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

L'objet de la Société consiste également au financement de toutes les sociétés faisant partie du groupe auquel la Société

appartient.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uni-

quement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de tous types de titres et instruments
de dette ou de capital. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment les revenus de tous emprunts, à ses filiales,
sociétés affiliées (comprenant société mère et société soeur), ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également
consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou
partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa
faveur et en faveur de toute autre société ou personne.

La Société peut employer tous les instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investissements et à sa pro-

tection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions

concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.

5. Durée. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

6. Responsabilité des Associés Commandités de la Société. Les Associés Commandités sont responsables de toutes

les obligations de la Société.

7. Gestion de la Société. La Société est gérée par un ou plusieurs Associés Commandités, responsables personnelle-

ment, indéfiniment et solidairement avec la Société des engagements que les actifs de la Société ne peuvent pas couvrir.

Le mandat de l'Associé Commandité ou des Associés Commandités ne sera pas rémunéré, sauf si l'Assemblée Générale

en décide autrement.

L'Associé Commanditaire ne pendra en aucun cas part à la gestion de la Société et n'aura aucun droit ou aucune

autorité pour agir pour la Société ou prendre part à, ou interférer dans, la gestion de la Société y compris en tant que
mandataire des Associés Commandités.

8. Autorité des Associés Commandités. L'Associé Commandité peut ou les Associés Commandités peuvent exécuter

tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, sauf ceux réservés à l'Assemblée Générale par les
Statuts ou la Loi

Les Associés Commandités auront pleins pouvoirs pour mener et approuver pour la Société tous les actes et opéra-

tions compatibles avec l'objet social de la Société.

76481

L

U X E M B O U R G

En cas de pluralité d'Associés Commandités, les décisions des Associés Commandités seront valablement prises à la

majorité des Associés Commandités.

Les Associés Commandités peuvent déléguer l'exécution d'une partie de leur autorité à un tiers par procuration

spéciale.

9. Représentation. La Société sera engagée par la seule signature de son Associé Commandité ou, en cas de pluralité

d'Associés Commandités, par un Associé Commandité quel qu'il soit.

La Société sera également engagée envers les tiers par la seule signature de toute personne à qui le pouvoir de signer

pour le compte de la Société a été valablement délégué par l'Associé Commandité ou les Associés Commandités con-
formément à l'article 10.2. des Statuts.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Actavis International Holding S.à r.l.

Référence de publication: 2014076020/66.
(140089479) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2014.

Gamax Management AG, Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 40.494.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-third day of May.
Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.

Was held

an extraordinary general meeting of shareholders of Gamax Management AG (the “Company”), a public limited com-

pany (“société anonyme”) with registered office at 11/13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, incorporated by a
deed of Maître Reginald Neuman, then notary residing in Luxembourg, dated June 16, 1992 which has been published in
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the “Mémorial”), number 312 dated July 21, 1992. The articles of
incorporation (the “Articles”) have been amended for the last time by a notarial deed of the undersigned notary, dated
October 23, 2012 and published in the Mémorial number 2935 dated 4 December 2012.

The meeting was opened at 3.00 p.m. under the chairmanship of Mr Marc Hirtz, lawyer, professionally residing in

Luxembourg,

who appointed as secretary Mrs Janine Wollenweber, lawyer, professionally residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mrs Elena Bassi, private employee, professionally residing in Luxembourg.
After the constitution of the board of the meeting, the Chairman declared and requested the notary to record that:
I. The names of the shareholders present at the meeting or duly represented by proxy, the proxies of the shareholders

represented, as well as the number of shares held by each shareholder, are set forth on the attendance list, signed by the
shareholders present, the proxies of the shareholders represented, the members of the board of the meeting and the
notary. The aforesaid list shall be attached to the present deed and registered therewith. The proxies given shall be
initialled “ne varietur” by the members of the board of the meeting and by the notary and shall be attached in the same
way to this document and registered therewith.

II. The quorum of at least one half of the capital is required by Article 67-1 (2) of the Luxembourg law of August 10,

1915 (the “Law of 1915”) on commercial companies, as amended, and the resolution on each item of the agenda has to
be passed by the affirmative vote of at least two thirds (2/3) of the votes cast in the meeting.

III. The agenda of the present meeting is the following:

<i>Agenda

1. Decrease of the corporate capital of the Company from seven million one hundred and sixty-one thousand Euro

(7,161,000 EUR) to two million Euro (2,000,000 EUR) by cancellation of 13,100 shares currently held by Banca Mediolanum
S.p.A. and subsequent reimbursement to Banca Mediolanum S.p.A..

2. Decrease of the statutory reserve of the Company from seven hundred eighty-five thousand four hundred and eight

Euro (785,408 EUR) to two hundred thousand Euro (200,000 EUR).

3. Decrease of the par value per share of the Company from three hundred and ten Euro (310 EUR) to two hundred

Euro (200 EUR) each.

4. Amendment of the Article 5, paragraph 1 of the Articles.
IV. Pursuant to the attendance list, 100 per cent of the issued shares of the Company are present or represented at

the meeting.

V. No convening notices were necessary as (i) the whole corporate capital being present or represented at the present

meeting and all the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of
the agenda prior to this meeting and (ii) all shareholders present or represented declaring to be aware of the envisaged

76482

L

U X E M B O U R G

modality for reducing the corporate capital of the Company by way of a cancellation of shares and the subsequent payment
of the proceeds to the relevant shareholder.

VI. Consequently, the present meeting is duly constituted and can there-fore validly deliberate on the aforementioned

items of the agenda.

After deliberation, the general meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First Resolution

The meeting resolved to reduce the corporate capital of the Company from seven million one hundred and sixty-one

thousand  Euro  (7,161,000  EUR)  to  two  million  Euro  (2,000,000  EUR)  by  cancelling  thirteen  thousand  one  hundred
(13,100) shares currently held by Banca Mediolanum S.p.A. and by subsequently reimbursing the amount of four million
sixty-one thousand Euro (EUR 4,061,000,-) to Banca Mediolanum S.p.A.

<i>Second Resolution

The meeting resolved to reduce the statutory reserve of the Company from seven hundred eighty-five thousand four

hundred and eight Euro (785,408 EUR) to two hundred thousand Euro (200,000 EUR).

<i>Third Resolution

The meeting resolved to reduce the par value per share of the Company from three hundred and ten Euro (310 EUR)

to two hundred Euro (200 EUR) and to repay the amount of one million one hundred thousand Euro (EUR 1,100,000.-)
to the shareholders in the proportion of their participation in the share capital.

The Shareholders give power to the Board of Directors in order to carry on all operations related to the reduction

in the scope of the legal duties, defined in the article 69 of the Luxembourg law of August 10 

th

 , 1915, on commercial

companies.

<i>Fourth Resolution

The meeting resolved to amend Article 5, paragraph 1 of the Articles, which shall henceforth read as follows:

“ Art. 5. The corporate capital is set at two million Euro (2,000,000 EUR), divided into ten thousand (10,000) shares

with a par value of two hundred Euro (EUR 200) each.”

There being no further business, the meeting is closed at 3.30 p.m.

<i>Expenses

The aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company

incurs or for which it is liable by reason of the present amendments, is approximately EUR 1,600.-.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the meeting, the members of the board of the meeting, all of whom are known to

the notary by their names, surnames, civil status and residences, signed together with us, the notary, the present original
deed, no shareholder expressing the wish to sign.

Follows the German translation:

Im Jahre zweitausendvierzehn, am dreiundzwanzigsten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg.
Wurde eine außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Gamax Management AG (die „Gesellschaft“)

abgehalten, einer Aktiengesellschaft („société anonyme“), mit Sitz in 11/13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg,
gegründet unter durch notarielle Urkunde von Maître Reginald Neuman, Notar mit dem damaligen Amtssitz in Luxem-
bourg, vom 16. Juni 1992, welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (das “Mémorial”), Nummer 312
vom 21. Juli 1992 veröffentlicht wurde. Die Satzung der Gesellschaft (die „Satzung“) wurde letztmalig am 23. Oktober
2012  gemäß  notarieller  Urkunde  des  unterzeichnenden  Notars  abgeändert  und  am  4.  Dezember  2012  im  Mémorial
Nummer 2935 veröffentlicht.

Die Versammlung wird um 15.00 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Marc Hirtz, Rechtsanwalt, beruflich ansässig in

Luxemburg eröffnet.

Der Vorsitzende beruft zum Sekretär Frau Janine Wollenweber, Rechtsanwältin, beruflich ansässig in Luxemburg.
Die Versammlung wählt einstimmig zur Stimmzählerin Frau Elena Bassi, Beamtin, beruflich ansässig in Luxemburg.
Es ersucht der Vorsitzende den amtierenden Notar Folgendes zu beurkunden:
I. Die Namen der in der Versammlung persönlich anwesenden oder rechtsgültig vertretenen Aktionäre, die der Be-

vollmächtigten der vertretenen Aktionäre sowie die Anzahl der Aktien, die von jedem Aktionär gehalten werden, gehen
aus der Anwesenheitsliste hervor, welche von den anwesenden Aktionären, den Bevollmächtigten der vertretenen Ak-
tionäre, den Mitgliedern des Präsidiums und dem amtierenden Notar unterzeichnet wurde. Die vorgenannte Anwesen-

76483

L

U X E M B O U R G

heitsliste  und  die  von  den  bevollmächtigten  Vertretern  und  dem  amtierenden  Notar  "ne  varietur"  gezeichneten
Vollmachten bleiben vorliegendem Protokoll beigefügt und werden mit ihm zusammen registriert.

II. Für eine Satzungsänderung ist gemäß Artikel 67-1 (2) des luxemburgischen Gesetzes vom 10. August 1915 über

Handelsgesellschaften in seiner letztgültigen Fassung ein Anwesenheitsquorum von 50% des Gesellschaftskapitals erfor-
derlich; die Beschlüsse sind entsprechend der Tagesordnung mit einer Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stimmen zu
fassen.

III. Die Tagesordnung der gegenwärtigen Generalversammlung lautet wie folgt:
1.  Herabsetzung  des  Gesellschaftskapitals  von  sieben  Millionen  einhunderteinundsechzigtausend  Euro  (EUR

7.161.000,-) auf zwei Millionen Euro (EUR 2.000.000,-) durch die Streichung von 13.100 Aktien, die zurzeit von Banca
Mediolanum S.p.A. gehalten werden, und dementsprechende Rückzahlung an Banca Mediolanum. S.p.A.

2. Herabsetzung der gesetzlichen Rücklagen der Gesellschaft von siebenhundertfünfundachtzigtausendvierhundertacht

Euro (EUR 785.408,-) auf zweihunderttausend Euro (EUR 200.000,-).

3. Herabsetzung des Nennwerts jeder Aktie von dreihundertzehn Euro (EUR 310,-) auf zweihundert Euro (EUR 200,-).
4. Änderung des Artikel 5, Absatz 1 der Satzung.
IV. Gemäß der Anwesenheitsliste sind 100% der ausgegebenen Aktien der Gesellschaft anwesend bzw. vertreten.
V. Sämtliche anwesenden oder vertretenen Aktionäre, die ihrerseits das gesamte Kapital der Gesellschaft repräsen-

tieren,  erklären,  bereits  vor  der  außerordentlichen  Generalversammlung  Kenntnis  von  der  Tagesordnung  gehabt  zu
haben, so dass die Versendung einer offiziellen Einladung zu der außerordentlichen Generalversammlung entbehrlich war.

VI. Dementsprechend ist die gegenwärtige Generalversammlung beschlussfähig und kann über die Tagesordnungs-

punkte entscheiden.

Nach Beratung fasst die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschließt, das Kapital der Gesellschaft von derzeit sieben Millionen einhunderteinundsech-

zigtausend Euro (EUR 7.161.000,-) auf zwei Millionen Euro (EUR 2.000.000,-) herabzusetzen durch die Streichung von
dreizehntausendeinhundert (13.100) Aktien, welche zurzeit von Banca Mediolanum S.p.A. gehalten werden, und durch
Rückzahlung des Betrages von vier Millionen einundsechzigtausend Euro (EUR 4.061.000,-) an Banca Mediolanum S.p.A.

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt, die gesetzlichen Rücklagen der Gesellschaft von siebenhundertfünfundachtzig-

tausendvierhundertacht Euro (EUR 785.408,-) auf zweihundert tausend Euro (EUR 200.000,-) herabzusetzen.

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt, den Nennwert jeder Aktie von dreihundertzehn Euro (EUR 310,-) auf zweihun-

dert Euro (EUR 200,-) herabzusetzen und den Betrag von einer Million einhunderttausend Euro (EUR 1.100.000,-) an die
Aktionäre im Verhältnis ihrer Beteiligung am Gesellschaftskapital zurückzuzahlen.

Die  Aktionäre  erteilen  dem  Verwaltungsrat  Vollmacht,  um  alle  Transaktionen  in  Bezug  auf  die  Herabsetzung  des

Kapitals im Umfang der gesetzlichen Pflichten gemäß Artikel 69 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsge-
sellschaften auszuführen.

<i>Vierter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt, Artikel 5, erster Absatz abzuändern um ihm fortan folgenden Wortlaut zu geben:

„ Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt zwei Millionen Euro (EUR 2.000.000,-), eingeteilt in zehntausend (10.000)

Aktien mit einem Nennwert von je zweihundert Euro (EUR 200.-).“

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen stellt der Vorsitzende fest, dass hiermit die Tagesordnung

erschöpft ist und schließt die Versammlung um 15.30 Uhr.

<i>Kosten

Die Gebühren, Ausgaben, Honorare und sonstigen Verbindlichkeiten gleich welcher Art, die durch die vorliegende

Beurkundung entstehen, trägt die Gesellschaft. Sie betragen schätzungsweise EUR 1.600,-.

Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache versteht und spricht stellt hiermit fest, dass die vorliegende

Urkunde auf Anfrage der Erschienenen in Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Auf Anfrage
derselben  Erschienenen  und  im  Falle  von  Abweichungen  zwischen  der  deutschen  und  der  englischen  Fassung  ist  die
englische Fassung maßgeblich.

Worüber Urkunde aufgenommen wird in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt. Nach Verlesung des Vorste-

henden an die Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen sowie Stand und Wohnort bekannt,
haben die Mitglieder des Präsidiums der Außerordentlichen Generalversammlung mit uns, dem Notar, die vorliegende
Original-Urkunde unterzeichnet. Kein Aktionär wünschte diese Original-Urkunde zu unterzeichnen.

Gezeichnet: J. WOLLENWEBER, E. BASSI, M. HIRTZ und H. HELLINCKX.

76484

L

U X E M B O U R G

Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 juin 2014. Relation: LAC/2014/25506. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

<i>Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions erteilt.

Luxemburg, den 11. Juni 2014.

Référence de publication: 2014082278/157.
(140097289) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2014.

WealthCap S.A. SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spé-

cialisé.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 152.769.

<i>Auszug aus der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre vom 10. Juni 2014

Aus dem Protokoll und den Beschlüssen der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der WealthCap S.A.

SICAF-SIF (die „Gesellschaft“) vom 10. Juni 2014 geht folgendes hervor:

- Die Versammlung beschließt, die PriceWaterhouseCoopers S.à.r.l., R.C.S. Luxembourg B 65477, mit Sitz in 400, route

d’Esch, L-1014 Luxembourg als Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2014 zu bestellen.

Gezeichnet: Mayers, Hermesdorf, Längsfeld.
Für gleichlautenden Auszug, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 10. Juni 2014.

Structured Invest S.A.
Silvia Mayers / Maren Hermesdorf

Référence de publication: 2014081947/18.
(140096397) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2014.

Sendosa S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 129.287.

In the year two thousand and fourteen, the sixth day of June, before Me Henri BECK, notary residing in Echternach,

Grand Duchy of Luxembourg,

was held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Sendosa S.à r.l. in liquidation, a Luxembourg

private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 20, Rue de la Poste, L-2346
Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under the number B 129.287 and
having a share capital of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) (the Company). The Company was incorpo-
rated  pursuant  to  a  deed  enacted  by  Maître  Martine  Schaeffer,  notary  residing  in  Luxembourg,  Grand  Duchy  of
Luxembourg on 4 June 2007 published on 9 August 2007 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, under
number 1682, page 80702. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended for the last time
by a deed of Me Henri Beck, notary residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg dated 30 December 2013,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 425, page 20372, dated 15 February 2014.

THERE APPEARED:

Stark Master Fund Ltd., a limited company incorporated under the laws of the British Virgin Islands, having its registered

office at Craigmuir Chambers, BVI - Road Town, Tortola, British Virgin Islands and registered with the British Virgin
Islands chamber of commerce under number 1010786 (the Sole Shareholder),

hereby represented by Peggy Simon, private employee, residing professionally in Echternach, 9, Rabatt, by virtue of a

power of attorney given under private seal.

Said power of attorney, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party

and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration
authorities.

The Sole Shareholder, represented as stated above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. that the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company;
II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:

76485

L

U X E M B O U R G

1. waiver of convening notices;
2. presentation of the report of the liquidation auditor (commissaire);
3. discharge (quitus) to the managers of the Company for all their duties during, and in connection with their mandate;
4. discharge (quitus) to Stark Master Fund Ltd., as liquidator (liquidateur) of the Company for all its duties during, and

in connection with, the voluntary liquidation (liquidation volontaire) of the Company;

5. discharge (quitus) to Stark Entity Services LLC, as liquidation auditor (commissaire) of the Company for all its duties

during, and in connection with, the voluntary liquidation (liquidation volontaire) of the Company;

6. decision to close the liquidation of the Company;
7. decision that the Company’s documents and books be kept for five (5) years from the date of publication of the

closing of the liquidation in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, at the following address: 20, rue de la
Poste, L-2346 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

8. granting of proxies; and
9. miscellaneous.
III. After having carefully considered the above, the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder declares that he has full knowledge of the items on the agenda and waives the requirement for

convocations.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder acknowledges and approves the report of Stark Entity Services LLC, appointed as liquidation

auditor (commissaire) of the Company pursuant to resolutions of the Company’s shareholder dated 14 May, 2014 on
the good performance of the actions taken and the liquidation report (rapport de liquidation) presented by Stark Master
Fund Ltd., appointed as liquidator (liquidateur) of the Company by the extraordinary general meeting of the shareholder
of the Company held on 30 December 2013 (the Liquidator) during the voluntary liquidation (liquidation volontaire) of
the Company.

The liquidation auditor informs the Sole Shareholder that all the liabilities of the Company have been settled or provided

for and that all the remaining assets of the Company have been paid so that the Company can be liquidated and that the
liquidation may therefore be closed.

The liquidation auditor confirms that the Liquidator has completed his mission with due care, that the Liquidator has

acted in the best interest of the Company.

<i>Third resolution

After having acknowledged the liquidation auditor’s report, the Sole Shareholder resolves to approve the Liquidator’s

report and the liquidation accounts dated 30 December 2013.

<i>Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves to give discharge (quitus) to all managers of the Company for the performance of all

their duties during and in connection with, their mandate.

<i>Fifth resolution

The Sole Shareholder resolves to give discharge (quitus) to Stark Master Fund Ltd., as Liquidator of the Company for

the performance of all his duties during, and in connection with, the voluntary liquidation (liquidation volontaire) of the
Company.

<i>Sixth resolution

The Sole Shareholder resolves to give discharge (quitus) to Stark Entity Services LLC, as liquidation auditor (commis-

saire) of the Company for the performance of all his duties during, and in connection with, the voluntary liquidation
(liquidation volontaire) of the Company.

<i>Seventh resolution

After considering that the existing assets of the Company have all been distributed to the Sole Shareholder of the

Company and that no liquidation proceeds are outstanding, and thus that no further distributions shall be made to the
shareholder of the Company, the Sole Shareholder resolves to close the liquidation as per the date of the present Meeting.

All expenses and outstanding liabilities related to this liquidation will be borne by the Sole Shareholder.

<i>Eighth resolution

The Sole Shareholder resolves to set the place where the Company’s documents and books are to be kept during five

(5) years from the date of publication of the closing of the liquidation in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,
C at the following address: 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

76486

L

U X E M B O U R G

<i>Ninth resolution

The Sole Shareholder resolves to give full power of attorney to any lawyer of Loyens &amp; Loeff Luxembourg S.à r.l. and

any employee of Citco REIF Services (Luxembourg) S.A., to file, register with the competent authorities any documents,
deeds, articles, instruments, agreements, notices, acknowledgments, statements, certificates, or any other document as
may be necessary or useful in connection with the liquidation of the Company, including but not limited to any outstanding
tax returns as well as the performance by the Company of the obligations contained therein.

<i>Costs

The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at approximately eight hundred fifty Euro (EUR 850.-).

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Echternach, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party

signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatorze, le sixième jour du mois de juin, par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à

Echternach, Grand-Duché de Luxembourg.

S’est tenue

une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) de l’associé unique de Sendosa S.à r.l., en liquidation, une société

à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 129.287 et disposant d’un
capital social de douze mille cinq cents euro (EUR 12.500,-) (la Société). La Société a été constituée suivant acte de Maître
Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 4 juin 2007, publié le
9 août 2007 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, sous le numéro 1682, page 80702. Les statuts de la
Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte de Maître Henri Beck notaire de résidence à
Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 30 Décembre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations numéro 425, page 20372, le 15 février 2014.

A COMPARU

Stark Master Fund Ltd., une société en commandite constituée selon les lois des Îles Vierges Britanniques, ayant son

siège social situé à Craigmuir Chambers Road Town, BVI, Tortola, Îles Vierges Britanniques et immatriculée auprès de la
chambre de commerce des Îles Vierges Britanniques, sous le numéro 1010786 (l’Associé Unique),

représenté par Peggy Simon, employée privée, avec adresse professionnelle à Echternach, 9, Rabatt, en vertu d’une

procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante

et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d’être soumise avec celui-ci aux formalités de l’enre-
gistrement.

L’Associé Unique a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. que l’Associé Unique représenté à l’Assemblée détient toutes les parts sociales dans le capital social de la Société;
II. que l’ordre du jour de l’Assemblée est libellé de la manière suivante:
1. renonciation aux formalités de convocation;
2. présentation du rapport du commissaire;
3. décharge (quitus) aux gérants de la Société pour l’exécution des toutes leurs fonctions pendant, et en relation avec,

leur mandat;

4. décharge (quitus) à Stark Master Fund Ltd. en tant que liquidateur de la Société pour l’exécution de toutes ses

fonctions pendant, et en relation avec, la liquidation volontaire de la Société;

5. décharge (quitus) à Stark Entity Services LLC en tant que commissaire de la Société pour l’exécution de toutes ses

fonctions pendant, et en relation avec, la liquidation volontaire de la Société;

6. décision de clôturer la liquidation de la Société;
7. décision de fixer le lieu où les livres et documents sociaux de la Société seront conservés pendant cinq (5) ans à

compter de la date de publication de la clôture de la liquidation au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C, à
l’adresse suivante: 20, Rue de la Poster, L-2346 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

8. octroi de pouvoirs; et

76487

L

U X E M B O U R G

9. divers.
III. Après avoir soigneusement examiné ce qui précède, l’Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Associé Unique déclare avoir pris connaissance de l’ordre du jour et renonce aux formalités de convocation.

<i>Deuxième résolution

L’Associé Unique décide de prendre acte et d’approuver le rapport de Stark Entity Services LLC, nommé commissaire

de la Société par résolutions écrites de l’actionnaire de la Société du 14 mai 2014, sur la bonne exécution des actions
entreprises et le rapport de liquidation présenté Stark Master Fund Ltd., nommé liquidateur de la Société par l’assemblée
générale extraordinaire de l’associé de la Société tenue le 30 Décembre 2013 (le Liquidateur) au cours de la liquidation
volontaire de la Société.

Le commissaire informe l’Associé Unique que toutes les dettes de la Société ont été réglées ou prévues et que tous

les actifs restants de la Société ont été payés afin que la Société puisse être liquidée et que la liquidation puisse être ainsi
clôturée.

Le commissaire confirme que le Liquidateur a rempli sa mission avec diligence et qu’il a agi dans le meilleur intérêt de

la Société.

<i>Troisième résolution

Après avoir pris acte du rapport du commissaire, l’Associé Unique décide d’approuver le rapport du Liquidateur ainsi

que les comptes de liquidation datés du 30 décembre 2013

<i>Quatrième résolution

L’Associé Unique décide de donner décharge (quitus) à tous les gérants de la Société pour l’exécution de toutes leurs

fonctions pendant, et en relation avec, leur mandat.

<i>Cinquième résolution

L’Associé Unique décide d’accorder décharge (quitus) à Stark Master Fund Ltd. en tant que Liquidateur de la Société

pour l’exécution de ses fonctions pendant, et en relation avec, la liquidation volontaire de la Société.

<i>Sixième résolution

L’Associé Unique décide d’accorder décharge (quitus) à Stark Entity Services LLC en tant que commissaire de la Société

pour l’exécution de ses fonctions pendant, et en relation avec, la liquidation volontaire de la Société.

<i>Septième résolution

Tous les actifs restants de la Société ayant été distribués à l’Associé Unique de la Société et aucun boni de liquidation

n’étant en suspens, de sorte que plus aucune distribution ne sera faite à l’associé de la Société, l’Associé Unique décide
de clôturer la liquidation à la date de la présente Assemblée.

Toutes les dépenses et dettes éventuelles en rapport avec la liquidation seront prises en charge par l’Associé Unique.

<i>Huitième résolution

L’Associé Unique décide de fixer le lieu où les livres et documents sociaux de la Société seront conservés pendant

cinq (5) ans à compter de la date de publication de la clôture de la liquidation au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations, C, à l’adresse suivante: 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

<i>Neuvième résolution

L’Associé Unique décide de donner pouvoir à tout avocat de Loyens &amp; Loeff Luxembourg S.à r.l. ainsi qu’à tout employé

de Citco REIF Services (Luxembourg) S.A. afin de déposer, enregistrer auprès des autorités compétentes tous documents,
actes, articles, instruments, contrats, avis, reconnaissances, déclarations, certificats, ou tous autres documents pouvant
être nécessaires ou utiles en relation avec la liquidation de la Société, en ce compris mais non limité à toutes déclarations
fiscales en suspens ainsi que l’exécution par la Société des formalités y relatives.

<i>Frais

Les dépenses, frais et rémunérations et charges, de toute nature, qui pourraient incomber à la Société à la suite du

présent acte sont estimés à environ huit cent cinquante Euros (EUR 850,-).

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur demande de la partie comparante, le présent acte

est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. A la demande de la même partie comparante et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Echternach, date qu’en tête des présentes.

76488

L

U X E M B O U R G

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé le présent acte

avec le notaire.

Signé: P. SIMON, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 10 juin 2014. Relation: ECH/2014/1091. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

Echternach, le 13 juin 2014.

Référence de publication: 2014084127/196.
(140098783) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2014.

ACRON Wien West A3 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 171.484.

In the year two thousand and fourteen, on the third of June.
Before Us, Maître Henri HELLINCKX, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held

an Extraordinary General Meeting of the shareholders of ACRON Wien West A3 S.A., a Luxembourg public limited

company (société anonyme), having its registered office at 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, registered
with the R.C.S. Luxembourg under number B 171.484, which has been incorporated pursuant to a deed of Maître Martine
Schaeffer, notary residing in Luxembourg, on September 13 

th

 , 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés

et  Associations,  number  2551  on  October  13 

th

  ,  2012  (hereinafter  referred  to  as  the  "Company").  The  articles  of

association of the Company have been amended for the last time by a deed of Maître Martine Schaeffer, prenamed, dated
June 4 

th

 , 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1427 on June 17 

th

 , 2013.

The Meeting is declared open and is presided over by Mr Cristian CANIS, private employee, residing professionally in

Luxembourg,

who appoints as secretary on the Meeting Ms Manuela DIETRICH, private employee, residing professionally in Lu-

xembourg.

The meeting elects as scurtineer Mr Jean WANTZ, private employee, residing professionally in Luxembourg.
The Shareholders, represented as stated above, have requested the undersigned notary to enact the following:
I. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance

list which will be signed and here annexed as well as the proxies and registered with the minutes.

II. All the shares being registered shares, the Extraordinary General Meeting has been validly convened by registered

mail addressed to all the Shareholders on April 29, 2014, i.e. no later than eight days prior to the date of the Meeting as
required by law.

III. Currently, the share capital as of today amounts to EUR 34,085,885 (thirty-four million eighty-five thousand eight

hundred and eighty-five euro) and is divided into 3,446,500 (three million four hundred and forty-six thousand five hun-
dred) registered shares with a par value of EUR 9.89 (nine euro and eighty-nine cents) each.

Pursuant to Article 6 of the articles of association of the Company, resolutions on the amendment of the articles of

association are subject to a quorum of two thirds of the share capital present or represented and need to be passed with
a majority of two thirds of the votes cast.

IV.- As it appears from the attendance list, 2,596,500 (two million five hundred and ninety-six thousand five hundred)

shares are represented at the present extraordinary general meeting, so that the meeting is regularly constituted and can
validly decide on all the items of the agenda.

V. The agenda of the Extraordinary General Meeting is worded as follows:

<i>Agenda

1. Decrease of the share capital of the Company in an amount of EUR 2,240,225 (two million two hundred and forty

thousand two hundred and twenty-five euro) in order to bring it from its present amount of EUR 34,085,885 (thirty-four
million eighty-five thousand eight hundred and eighty-five euro) to the amount of EUR 31,845,660 (thirty-one million eight
hundred and forty-five thousand six hundred and sixty euro), by the reduction of the par value of each share from EUR
9.89 (nine euro and eighty-nine cents) by EUR 0.65 (sixty-five cents) to EUR 9.24 (nine euro and twenty-four cents); the
reduction is to be carried out by means of a repayment to the shareholders;

2. Adaptation and restatement of Article 3 of the articles of association of the Company to the decrease of the share

capital;

76489

L

U X E M B O U R G

3. Amendment of the shareholders’ register of the Company to the above-mentioned merger of shares and decrease

of the share capital;

4. Miscellaneous.
After the foregoing has been approved by the Meeting, the same unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The Shareholders resolve to decrease the share capital of the Company in an amount of EUR 2,240,225 (two million

two hundred and forty thousand two hundred and twenty-five euro) in order to bring it from its present amount of EUR
34,085,885 (thirty-four million eighty-five thousand eight hundred and eighty-five euro) to the amount of EUR 31,845,660
(thirty-one million eight hundred and forty-five thousand six hundred and sixty euro), by the reduction of the par value
of each share from EUR 9.89 (nine euro and eighty-nine cents) by EUR 0.65 (sixty-five cents) to EUR 9.24 (nine euro and
twenty-four cents); the reduction is to be carried out by means of a repayment to the shareholders in the proportion of
their participation in the share capital.

The Shareholders give power to the Board of Directors in order to carry on all operations related to the reduction

in the scope of the legal duties, defined in the article 69 of the Luxembourg law of August 10 

th

 , 1915, on commercial

companies.

<i>Second resolution

The Shareholders resolve to adapt Article 3 of the articles of association to the aforementioned change so that it can

be read from now on as follows:

“ Art. 3. The share capital is set at EUR 31,845,660 (thirty-one million eight hundred and forty-five thousand six hundred

and sixty euro), represented by 3,446,500 (three million four hundred and forty-six thousand five hundred) shares in
registered form, having a nominal value of EUR 9.24 (nine euro and twenty-four cents) each, all subscribed and fully paid-
up.

The Company may, to the extent and under terms permitted by law redeem its own shares.”

<i>Third resolution

The Shareholders resolve to amend the shareholders’ register of the Company in order to reflect the above changes

and hereby grant power and authority to any director of the Company and/or any employee of Pandomus to proceed
on behalf of the Company with the registration of the amended share capital, the amended number of shares and the
amended par value of the shares in the shareholders’ register.

Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the notary closed the Extraordinary Meeting.

<i>Expenses

The aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company

incurs or for which it is liable by reason of the present amendments, is approximately EUR 1,600.-.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English and German, states herewith that on request of the

appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a German version and in case of discrepancies
between the English and the German text, the English version will prevail.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the appearing persons, such appearing persons signed together with the notary

the present original deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes:

Im Jahre zweitausend und vierzehn, am dritten Juni.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri HELLINCKX mit dem Amtssitz in Luxemburg.
Wurde eine außerordentliche Generalversammlung der Gesellschafter der ACRON Wien West A3 S.A., einer Lu-

xemburger Aktiengesellschaft (société anonyme) mit Sitz in 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxemburg, eingetragen
im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter der Nummer B 171.484, gegründet gemäß Urkunde aufge-
nommen durch Maître Martine Schaffer, Notar mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg, am 13. September 2012, veröf-
fentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 2551 am 13. Oktober 2012 (nachfolgend als
„Gesellschaft“ bezeichnet) abgehalten. Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt am 4. Juni 2013 durch Urkunde von
Maître Martine Schaeffer, vorbenannt, abgeändert und im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, unter der
Nummer 1427 am 17 Juni 2013 veröffentlicht.

Die Versammlung wird eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Cristian CANIS, Angestellter, beruflich wohnhaft in

Luxemburg,

die zum Schriftführer ernennt, Frau Manuela DIETRICH, Angestellte, beruflich wohnhaft in Luxemburg.

76490

L

U X E M B O U R G

Die Gesellschafterversammlung wählt zum Stimmenzähler Herr Jean WANTZ, Angestellter, beruflich wohnhaft in

Luxemburg.

Die Aktionäre, wie oben benannt, haben sodann den amtierenden Notar ersucht, Folgendes zu beurkunden:
I. Gegenwärtigem Protokoll ist ein Verzeichnis der Aktien sowie der anwesenden und vertretenden Aktionären bei-

gegeben. Diese Anwesenheitsliste nebst Vollmachten werden, nachdem sie unterschrieben wurde, mit der gegenwärtigen
Urkunde ein registriert.

Da sämtliche Aktien Namensaktien sind wurde die außerordentliche Generalversammlung ordnungsgemäß durch, an

alle Aktionäre adressierte Einschreibesendungen vom 29. April 2014, das heißt spätestens acht Tage vor Abhaltung der
Versammlung, wie gesetzlich vorgesehen, über die außerordentliche Generalversammlung einberufen.

III. Gegenwärtig beträgt das Aktienvermögen EUR 34.085.885 (vierunddreißig Millionen fünfundachtzig Tausend acht-

hundert und fünfundachtzig Euro) und ist in 3.446.500 (drei Millionen vierhundert und sechsundvierzig tausend fünfhun-
dert) Aktien mit einem Nennbetrag von je EUR 9,89 (neun Euro und neunundachtzig Cents) eingeteilt.

Satzungsändernde Beschlüsse bedürfen nach Artikel 6 der Satzung der Gesellschaft der Anwesenheit von zwei Dritteln

des Gesellschaftskapitals und einer Mehrheit von zwei Drittel der abgegebenen Stimmen.

IV. Wie aus der Anwesenheitsliste hervorgeht, sind 2.596.500 (zwei Millionen fünfhundertsechsundneunzig tausend

fünf hundert) Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten, somit ist die Versamm-
lung demnach ordentlich zusammengesetzt und kann rechtsgültig über die Tagesordnung abstimmen.

V. Die Tagesordnung lautet wie folgt:

<i>Tagesordnung

1. Kapitalherabsetzung um EUR 2.240.225 (zwei Millionen zweihundert und vierzig Tausend zwei hundert und fünf-

undzwanzig  Euro)  von  derzeit  EUR  34.085.885  (vierunddreißig  Millionen  fünfundachtzig  Tausend  achthundert  und
fünfundachtzig Euro) auf EUR 31.845.660 (einunddreißig Millionen achthundert und fünfundvierzig Tausend sechshundert
und sechzig Euro) durch Herabsetzung des Nennwerts jeder Aktie von EUR 9,89 (neun Euro und neunundachtzig Cents)
um EUR 0,65 (fünfundsechzig Cent) auf EUR 9,24 € (neun Euro und vierundzwanzig Cent); die Kapitalherabsetzung erfolgt
durch Rückzahlung an die Aktionäre;

2. Anpassung und Änderung des Artikel 3 der Satzung der Gesellschaft an die Kapitalherabsetzung;
3. Änderungen des Aktienregisters der Gesellschaft
4. Verschiedenes.
Nach Beratung traf die Versammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Aktionäre beschließen, das Kapital der Gesellschaft um EUR 2.240.225 (zwei Millionen zweihundert und vierzig

Tausend zwei hundert und fünfundzwanzig Euro) von derzeit EUR 34.085.885 (vierunddreißig Millionen fünfundachtzig
Tausend achthundert und fünfundachtzig Euro) auf EUR 31.845.660 (einunddreißig Millionen achthundert und fünfund-
vierzig Tausend sechshundert und sechzig Euro) herabzusetzen durch Herabsetzung des Nennwerts jeder Aktie von EUR
9,89 (neun Euro und neunundachtzig Cents) um EUR 0,65 (fünfundsechzig Cent) auf EUR 9,24 € (neun Euro und vier-
undzwanzig Cent); die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Rückzahlung an die Aktionäre im Verhältnis ihrer Beteiligung
am Gesellschaftskapital.

Die Aktionäre erteilen dem Verwaltungsrat Vollmacht um alle Transaktionen in Bezug auf die Herabsetzung des Ka-

pitals im Umfang der gesetzlichen Pflichten gemäß Artikel 69 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesell-
schaften auszuführen.

<i>Zweiter Beschluss

Die Aktionäre beschließen, Artikel 3 der Satzung der Gesellschaft an die zuvor beschlossene Kapitalherabsetzung

anzupassen und wie folgt neu zu fassen:

„ Art. 3. Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt EUR 31.845.660 (einunddreißig Millionen achthundert und fünf-

undvierzig Tausend sechshundert und sechzig Euro), eingeteilt in 3.446.500 (drei Millionen vierhundert und sechsund-
vierzig tausend fünfhundert) Aktien mit einem Nominalwert von je EUR 9,24 (neun Euro und vierundzwanzig Cents), die
sämtlich voll eingezahlt wurden.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien

zurückkaufen.“

<i>Dritter Beschluss

Die Aktionäre beschließen, das Aktienregister der Gesellschaft an die zuvor beschlossenen Änderungen anzupassen

und beauftragen und bevollmächtigen jedes Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft und/oder jeden Mitarbeiter von
Pandomus im Namen der Gesellschaft die Änderung des Gesellschaftskapitals, der Anzahl an Aktien sowie des Nennwerts
der Aktien im Aktienregister zu registrieren.

Mangels weiterer Tagesordnungspunkte und Wortmeldungen schließt der amtierende Notar die Versammlung.

76491

L

U X E M B O U R G

<i>Kosten

Die Gebühren, Ausgaben, Honorare und sonstigen Verbindlichkeiten gleich welcher Art, die durch die vorliegende

Beurkundung entstehen, trägt die Gesellschaft. Sie betragen schätzungsweise EUR 1.600,-.

<i>Erklärung

Der unterzeichnende Notar, der der englischen und deutschen Sprache mächtig ist, erklärt hiermit, dass auf Ersuchen

der erschienenen Personen diese Urkunde in englischer Sprache verfasst und mit einer deutschen Übersetzung versehen
ist und dass im Falle einer Abweichung des englischen Textes vom deutschen Text, der englische Text maßgeblich ist.

Worüber die vorliegende Urkunde zum oben genannten Datum in Luxemburg erstellt wird.
Nach Vorlesen und Erklärung alles Vorstehenden haben die erschienenen Personen mit uns, der unterzeichnende

Notar, die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: C. CANIS, M. DIETRICH, J. WANTZ und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 4 juin 2014. Relation: LAC/2014/25964. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

<i>Le Receveur ff.

 (signé): C. FRISING.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions erteilt.

Luxemburg, den 13. Juni 2014.

Référence de publication: 2014083481/171.
(140099017) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2014.

T. Rowe Price Funds Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6C, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 82.218.

In the year two thousand and fourteen, on the second day of June.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held

an extraordinary general meeting of shareholders of T. ROWE PRICE FUNDS SICAV, having its registered office at

6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg (the «Company»), incorporated on June 5,
2001, the articles of incorporation of which (the «Articles of Incorporation») were published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations (the «Mémorial C»), on July 4, 2001 and registered with the Luxembourg Trade and Com-
panies  Register  under  n°  B  82.218.  The  Articles  of  Incorporation  were  amended  for  the  last  time  by  deed  of  the
undersigned notary, on June 2, 2009, published in the Mémorial C number 1331, on July 10, 2009.

The meeting was declared open at 2.30 p.m. and was presided over by Mr Xavier Rouvière, employee, professionally

residing in Senningerberg who appointed, Mr Brian Flanagan, employee, professionally residing in Senningerberg as se-
cretary of the meeting.

The meeting elected as scrutineer, Mrs Rachel Carletti, employee, professionally residing in Senningerberg.
The Chairman declared and requested the notary to state that:
I.- The shareholders represented and the numbers of shares held by each of them are shown on an attendance list

signed by the proxies of the shareholders represented and by the members of the bureau. The said list and proxies
initialled "ne varietur" by the members of the bureau will be annexed to this document, to be registered with this deed.

II.- This meeting has been convened by notices containing the agenda sent to each of the shareholders registered in

the shareholders' register on 15 April 2014 and published in the Mémorial, in the Tageblatt and in the Luxemburger Wort
on 30 April 2014 and on16 May 2014.

III.- The agenda of the extraordinary general meeting is the following:

<i>Agenda

1. To amend article 3 to replace the references to “the law of 20 December 2002” and to “the 2002 Law” by references

to “the law of 17 December 2010” and “the 2010 Law” respectively.

2. To amend article 8 in order to delete the definition of “U.S. Person” and to replace it by a cross-reference to the

Company’s current prospectus.

3. To amend article 14 to clarify in the second paragraph that shareholder meetings may be presided by any person.
4. To amend article 16 (i) to replace the references to “the 2002 Law” by a reference to “the 2010 Law”, to replace

the references to “Directive 85/611/EEC” by a reference to “Directive 2009/65/EC”, to replace the references to “first
and second indents” by a reference to “(a) and (b)”, (ii) to provide that any Fund of the Company can, under the conditions
of the law of 17 December 2010, invest into one or several other Funds of the Company and (iii) to allow for the possibility
of creating feeder Funds.

76492

L

U X E M B O U R G

5. To amend article 20 to replace the reference to “Article 113 of the 2002 Law” by a reference to “Article 154 of

the 2010 Law”.

6. To amend article 21 (i) to replace the reference to “the 2002 Law” by a reference to “the 2010 Law”, (ii) in the fifth

last paragraph, to delete the references to mergers and to compulsory redemption of the Company as a whole as well
as to replace the requirement for a thirty days’ prior notice in case of compulsory redemption of a Fund by a notice
period to be determined by the board of directors and to indicate that the last redemption net asset value be determined
by the board in its notice, (iii) to delete the words “or its merger with another Fund of the Company or with another
Luxembourg UCITS, in each case” as well as the words “or merged” in the fourth last paragraph, (iv) to delete the third
and second last paragraphs and (v) to add, at the end of the article two paragraphs relating to the merger provisions
applicable under the 2010 Law.

7. To amend article 22 to add a paragraph i) providing that the subscriptions and/or redemptions of Shares may be

suspended in case of a merger of a Fund or of the Company and to add a paragraph h) providing that that the subscriptions
and/or redemptions of Shares of a Fund that is a feeder fund may be suspended in case of suspension of the subscriptions
and/or redemptions of shares of the master fund.

8. To amend article 25 by deleting the words “sent to registered Shareholders and/or published and” in the last

paragraph.

9. To amend article 27 by updating the name of T. Rowe Price Global Investment Services Limited” to “T. Rowe Price

International Ltd”.

10. To amend article 28 by replacing “Article 107 of the 2002 Law” by “Article 146 of the 2010 Law” in the last

paragraph.

11. To amend article 30 to replace the reference to “the 2002 Law” by a reference to “the 2010 Law”.
12. To decide that the restated Articles be solely drafted in English and not be followed by a French translation.
IV. - As appears from the said attendance list out of 442,557,186.23 shares in issue, 8,521,088 shares are present or

duly represented at this Extraordinary General Meeting. The Chairman informs the meeting that a first extraordinary
general meeting has been convened with the same agenda as the agenda of the present meeting indicated above, for the
25 

th

 April 2014 and that the quorum requirements for voting the items of the agenda had not been attained.

In accordance with Article 67-1 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, the present meeting may

thus deliberate validly no matter how many shares are represented.

The Chairman of the meeting commented the proposed changes and the shareholders adopted by more than two

third majority votes, as detailed in the attendance list, the following resolutions:

<i>First resolution

The shareholders of the Company RESOLVED to amend article 3 to replace the references to “the law of 20 December

2002” and to “the 2002 Law” by references to “the law of 17 December 2010” and “the 2010 Law” respectively, so that
article 3 shall now read as follows:

“The exclusive object of the Company is to place the funds available to it in transferable securities of all types and all

other permitted assets such as referred to in Article 41 (1) of the law of 17 December 2010 regarding undertakings for
collective investment or any legislative replacements or amendments thereof (the “2010 Law”) with the purpose of
spreading investment risks and affording its shareholders the results of the management of its portfolio.

The Company may take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment

and development of its purpose to the full extent permitted by the 2010 Law.”

<i>Second resolution

The shareholders of the Company RESOLVED to amend article 8 in order to delete the definition of “U.S. Person”

and to replace it by a cross-reference to the Company’s current prospectus, so that article 8 shall now read as follows:

“The Board shall have power to impose such restrictions (other than any restrictions on transfer of Shares) as it may

think necessary for the purpose of ensuring that no Shares in the Company or no Shares of any Fund are acquired or
held by or on behalf of (a) any person in breach of the law or requirements of any country or governmental or regulatory
authority or (b) any person in circumstances which in the opinion of the Board might result in the Company incurring
any liability to taxation, or suffering any other pecuniary disadvantage which the Company might not otherwise have
incurred or suffered or (c) any person that violates the trading policy of the Company or any Fund, which policy is meant
to protect against both potential disruptions in portfolio management and increased expenses. In addition to the foregoing,
the Board may determine to restrict the purchase of shares when it is in the interest of the Company and/or its Share-
holders to do so, including when the Company or any Fund reaches a size that could impact the ability to find suitable
investments for the Company or Fund.

More specifically, the Company may restrict or prevent the ownership of Shares in the Company by any person, firm

or corporate body, and without limitation, by any "U.S. Person", as defined in the Company’s current prospectus.

For such purposes, the Company may:

76493

L

U X E M B O U R G

(a) decline to issue any Share where it appears to it that such issue would or might result in such Share being directly

or beneficially owned by a person, who is precluded from holding Shares in the Company,

(b) at any time require any person whose name is entered in the Register of Shareholders to furnish it with any

information, supported by affidavit, which it may consider necessary for the purpose of determining whether or not
beneficial ownership of such Shareholder's Shares rests in a person who is precluded from holding Shares in the Company,
and

(c) where it appears to the Company that any person, who is precluded from holding Shares in the Company, either

alone or in conjunction with any other person is a beneficial or registered owner of Shares, compulsorily redeem from
any such Shareholder all Shares held by such Shareholder in the following manner:

(1) the Company shall serve a notice (herein¬after called the "Redemption Notice") upon the Shareholder holding

such Shares or appearing in the Register of Shareholders as the owner of the Shares to be redeemed, specifying the Shares
to be redeemed as aforesaid, the price to be paid for such Shares, and the place at which the Redemption Price (as defined
below) in respect of such Shares is payable. Any such Redemption Notice may be served upon such Shareholder by posting
the same in a prepaid registered envelope addressed to such Shareholder at his last address known to or appearing in
the Register of Shareholders. Immediately after the close of business on the date specified in the Redemption Notice,
such Shareholder shall cease to be a Shareholder and the Shares previously held by him shall be cancelled. The said Share-
holder shall thereupon forthwith be obliged to deliver to the Company the Share certificate or certificates (if issued)
representing the Shares specified in the Redemption Notice;

(2) the price at which the Shares specified in any Redemption Notice shall be redeemed (herein called the "Redemption

Price") shall be an amount equal to the Dealing Price of Shares in the Company of the relevant Fund, determined in
accordance with Article 21 hereof;

(3) payment of the Redemption Price will be made to the Shareholder appearing as the owner thereof in the currency

of denomination of the relevant Fund and will be deposited by the Company with a bank in Luxembourg or elsewhere
(as specified in the Redemption Notice) for payment to such person but only, if a Share certificate shall have been issued,
upon surrender of the Share certificate or certificates representing the Shares specified in such notice. Upon deposit of
such price as aforesaid no person interested in the Shares specified in such Redemption Notice shall have any further
interest in such Shares or any of them, or any claim against the Company or its assets in respect thereof, except the right
of the Shareholder appearing as the owner thereof to receive the price so deposited (without interest) from such bank
as aforesaid;

(4) the exercise by the Company of the powers conferred by this Article shall not be questioned or invalidated in any

case, on the ground that there was insufficient evidence of ownership of Shares by any person or that the true ownership
of any Shares was otherwise than appeared to the Company at the date of any Redemption Notice, provided that in such
case the said powers were exercised by the Company in good faith; and

(d) decline to accept the vote of any person who is precluded from holding Shares in the Company at any meeting of

Shareholders of the Company.”

<i>Third resolution

The shareholders of the Company RESOLVED to amend article 14 to clarify in the second paragraph that shareholder

meetings may be presided by any person, so that the second paragraph of article 14 shall now read as follows:

“The chairperson shall preside at all meetings of the Board, but failing a chairperson or in his absence the directors

may appoint another director as chairperson pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Shareholder meetings may be presided by any person.”

<i>Fourth resolution

The shareholders of the Company RESOLVED to amend article 16 (i) to replace the references to “the 2002 Law” by

a reference to “the 2010 Law”, to replace the references to “Directive 85/611/EEC” by a reference to “Directive 2009/65/
EC”, to replace the references to “first and second indents” by a reference to “(a) and (b)”, (ii) to provide that any Fund
of the Company can, under the conditions of the law of 17 December 2010, invest into one or several other Funds of
the Company and (iii) to allow for the possibility of creating feeder Funds, so that article 16 shall now read as follows:

“The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in

the Company's interest. All powers not expressly reserved by law or by the present Articles, to the general meeting of
shareholders are in the competence of the Board of Directors.

The Board of Directors shall have the power to do all things on behalf of the Company which are not expressly

reserved to the shareholders in general meeting by these Articles and shall, without limiting the generality of the foregoing,
have the power to determine the corporate and investment policy for the investments relating to each Sub-Fund and the
portfolio relating thereto based on the principle of spreading of risks, subject to such investment restrictions as may be
imposed by the 2010 Law and by regulations and as may be determined by the Board of Directors.

The Board of Directors has, in particular, power to determine the corporate policy. The course of conduct of the

management and business affairs of the Company shall not effect such investments or activities as shall fall under such
investment restrictions as may be imposed by the 2010 Law or be laid down in the laws and regulations of those countries

76494

L

U X E M B O U R G

where the Shares are offered for sale to the public or as shall be adopted from time to time by resolution of the Board
of Directors and as shall be described in any prospectus relating to the offer of Shares.

In the determination and implementation of the investment policy the Board of Directors may cause the assets of the

Company to be invested in transferable securities and money market instruments, units of undertakings for collective
investment in transferable securities (“UCITS”) authorised according to Directive 2009/65/EC, as may be amended from
time to time (“Directive 2009/65/EC”) and/or other undertakings for collective investment (“UCIs”) within the meaning
of Article 1, paragraph (2) (a) and (b) of Directive 2009/65/EC, deposits with credit institutions, financial derivative ins-
truments and all other permitted assets such as referred to in Part I of the 2010 Law.

Such assets comprise but are not limited to:
(a) Transferable securities and money market instruments admitted to official listings on stock exchanges in Member

States of the European Union (the “EU”),

(b) Transferable securities and money market instruments dealt in on other regulated markets in Member States of

the EU, that are operating regularly, are recognised and are open to the public,

(c) Transferable securities and money market instruments admitted to official listings on stock exchanges in any other

country in Eastern and Western Europe, the American continent, Asia, Oceania and Africa,

(d) Transferable securities and money market instruments dealt in on other regulated markets that are operating

regularly, are recognised and open to the public of any other country in Eastern and Western Europe, the American
continent, Asia, Oceania and Africa,

(e) Recently issued transferable securities and money market instruments provided that the terms of the issue include

an undertaking that application will be made for admission to the official listing on one of the stock exchanges as specified
in a) and c) or regulated markets that are operating regularly, are recognised and open to the public as specified in b) and
d) and that such admission is secured within a year of issue,

(f) Units of UCITS and/or other UCIs within the meaning of Article 1, paragraph (2) (a) and (b) of Directive 2009/65,

whether they are situated in a Member State or not, provided that:

- such other UCIs are authorized under laws which provide that they are subject to supervision considered by the

Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”) to be equivalent to that laid down in Community law, and
that cooperation between authorities is sufficiently ensured;

- the level of protection for unitholders in the other UCIs is equivalent to that provided for unitholders in a UCITS,

and in particular that the rules on assets segregation, borrowing, lending, and uncovered sales of transferable securities
and money market instruments are equivalent to the requirements of Directive 2009/65/EC;

- the business of the other UCIs is reported in half-yearly and annual reports to enable an assessment to be made of

the assets and liabilities, income and operations over the reporting period;

- no more than 10 % of the UCITS' or other UCIs’ assets (or of the assets of any sub-fund thereof, provided that the

principle of segregation of liabilities of the different compartments is ensured in relation to third parties), whose acquisition
is contemplated, can, according to their constitutional documents, be invested in aggregate in units of other UCITS or
other UCIs;

The Funds will not invest more than 10% of their net assets into units of UCITS or other UCIs unless otherwise

provided for in respect of certain Funds by the Company’s current prospectus.

Notwithstanding the 10% limit above and if so provided for in respect of certain Funds by the Company’s current

prospectus:

A Fund can, under the conditions provided for in Article 181 paragraph 8 of the 2010 Law, invest in the shares issued

by one or several other Funds of the Company.

The Company may determine, under the conditions provided for in Chapter 9 of the 2010 Law, that a Fund (”Feeder”)

may invest at least 85% of its assets in units or shares of another UCITS (“Master”) authorised according to Directive
2009/65/EC (or a portfolio of such UCITS).

(g) deposits with credit institutions which are repayable on demand or have the right to be withdrawn, and maturing

in no more than 12 months, provided that the credit institution has its registered office in an EU Member State or, if the
registered office of the credit institution is situated in a non-Member State, provided that it is subject to prudential rules
considered by the CSSF as equivalent to those laid down in Community law;

(h) financial derivative instruments, including equivalent cash-settled instruments, dealt in on a regulated market; and/

or financial derivative instruments dealt in over-the-counter (“OTC derivatives”), provided that:

- the underlying consists of instruments described in sub-paragraphs (a) to (g) above, financial indices, interest rates,

foreign exchange rates or currencies, in which the Company may invest according to its investment objectives;

- the counterparties to OTC derivative transactions are institutions subject to prudential supervision, and belonging

to the categories approved by the CSSF and;

- the OTC derivatives are subject to reliable and verifiable valuation on a daily basis and can be sold, liquidated or

closed by an offsetting transaction at any time at their fair value at the Company’s initiative;

76495

L

U X E M B O U R G

(i) money market instruments other than those dealt in on a regulated market, which fall under Article 1 of the 2010

Law, if the issue or issuer of such instruments is itself regulated for the purpose of protecting investors and savings, and
provided that they are:

- issued or guaranteed by a central, regional or local authority or central bank of an EU Member State, the European

Central Bank, the EU or the European Investment Bank, a non-Member State or, in the case of a Federal State, by one
of the members making up the federation, or by a public international body to which one or more Member States belong
or;

- issued by an undertaking any securities of which are dealt in on regulated markets referred to in subparagraphs (a),

(b) or (c) above, or;

- issued or guaranteed by an establishment subject to prudential supervision, in accordance with criteria defined by

Community law, or by an establishment which is subject to and complies with prudential rules considered by the CSSF
to be at least as stringent as those laid down by Community law, or;

- issued by other bodies belonging to the categories approved by the CSSF provided that investments in such instru-

ments are subject to investor protection equivalent to that laid down in the first, the second or the third indent and
provided that the issuer is a company whose capital and reserves amount to at least EUR 10 million and which presents
and publishes its annual accounts in accordance with Directive 78/660/EEC (1), is an entity which, within a group of
companies which includes one or several listed companies, is dedicated to the financing of the group or is an entity which
is dedicated to the financing of securitisation vehicles which benefit from a banking liquidity line.

The Company may invest up to a maximum of 20 per cent. of the net assets of any Sub-Fund in equity and/or debt

securities issued by the same body when the aim of the investment policy of the given Sub-Fund is to replicate the
composition of a certain equity or debt securities index which is recognised by the CSSF, on the following basis:

- the composition of the index is sufficiently diversified,
- the index represents an adequate benchmark for the market to which it refers,
- it is published in an appropriate manner.
This limit is 35% where that proves to be justified by exceptional market conditions in particular in regulated markets

where certain transferable securities or money market instruments are highly dominant. Investment up to this limit is
permitted only in the securities of a single issuer.

The Company may invest up to a maximum of 35 per cent. of the assets of any Sub-Fund in transferable securities or

money market instruments issued or guaranteed by an EU Member State, its local authorities, by a non-Member State or
by public international bodies to which one or more Member States belong.

The Company may invest up to 100 per cent. of the assets of any Sub-Fund, in accordance with the principle of risk

spreading, in different transferable securities and money market instruments issued or guaranteed by an EU Member
State, its local authorities, by another member State of the OECD or public international bodies of which one or more
Member States are members, provided that (i) such securities are part of at least six different issues, and (ii) securities
from any one issue do not account for more than 30 per cent of the total assets of such Sub-Fund.”

<i>Fifth resolution

The shareholders of the Company RESOLVED to amend article 20 to replace the reference to “Article 113 of the

2002 Law” by a reference to “Article 154 of the 2010 Law”, so that article 20 shall now read as follows:

“The Company shall appoint an authorised auditor who shall carry out the duties prescribed by Article 154 of the

2010 Law.”

<i>Sixth resolution

The shareholders of the Company RESOLVED to amend article 21 (i) to replace the reference to “the 2002 Law” by

a reference to “the 2010 Law”, (ii) in the fifth last paragraph, to delete the references to mergers and to compulsory
redemption of the Company as a whole as well as to replace the requirement for a thirty days’ prior notice in case of
compulsory redemption of a Fund by a notice period to be determined by the board of directors and to indicate that the
last redemption net asset value be determined by the board in its notice, (iii) to delete the words “or its merger with
another Fund of the Company or with another Luxembourg UCITS, in each case” as well as the words “or merged” in
the fourth last paragraph, (iv) to delete the third and second last paragraphs and (v) to add, at the end of the article two
paragraphs relating to the merger provisions applicable under the 2010 Law, so that article 21 shall now read as follows:

“As is more specifically prescribed hereinbelow, the Company has the power to redeem its own Shares at any time

within the sole limitations set forth by the 2010 Law.

Any Shareholder may request the redemption of all or part of his Shares by the Company provided that
(i) the Company may, if compliance with such request would result in a holding of Shares in the Company of an aggregate

amount or number of Shares as the Board may determine from time to time and disclosed in the prospectus, redeem all
the remaining Shares held by such Shareholder; and

(ii) the Company shall not be bound to redeem on any Dealing Day or in any period of seven consecutive Dealing

Days more than 10% of the total Net Asset Value of Shares of any Fund in issue on such valuation day.

76496

L

U X E M B O U R G

If on any Dealing Day, or in any period of seven consecutive Dealing Days, the Company receives requests for re-

demptions of a greater value of Shares, it may declare that such redemptions are deferred until a Dealing Day not more
than seven Dealing Days following such time. Any redemption requests in respect of the relevant Dealing Day so reduced
will be effected in priority to subsequent redemption requests received on the succeeding Dealing days, subject always
to the 10% limit. The limitation will be applied pro rata to all Shareholders who have requested redemptions to be effected
on or as at such Dealing Day so that the proportion redeemed of each holding so requested is the same for all such
Shareholders.

For the purpose of this article, conversions are considered as redemptions.
Whenever the Company shall redeem Shares, the price at which such Shares shall be redeemed by the Company shall

be the Dealing Price per Share of the relevant Fund (as determined in accordance with the provisions of Article 23 hereof)
determined on the Dealing Day when or immediately after a written and irrevocable redemption request is received, less
a redemption charge, as may be decided by the Board from time to time and described in the then current prospectus.

The redemption proceeds shall be paid normally within five Business Days after the date on which the applicable dealing

price ("Dealing Price") was determined or, if later, on the date the written confirmation, or as the case may be, Share
certificates (if issued) have been received by the Company. Any such request must be filed or confirmed by such Share-
holder  in  written  form  at  the  registered  office  of  the  Company  in  Luxembourg  or  with  any  other  person  or  entity
appointed by the Company as its agent for redemption of Shares. Evidence of transfer or assignment accompanied by the
certificate(s) (with redemption requests thereon), representing the shareholding, if issued in certificated form, must be
received by the Company or its agent appointed for that purpose before the redemption monies may be paid. Shares in
the capital of the Company redeemed by the Company shall be cancelled.

The Company shall, if the Shareholder requesting redemption so accepts, have the right to satisfy payment of re-

demption price in kind by allocating to such Shareholder assets from the Fund equal in value to the value of the Shares
to be redeemed. The nature and type of such assets shall be determined on a fair and reasonable basis and without
prejudicing the interests of the other Shareholders and the valuation used shall be confirmed by a report of the Company's
auditor.

Any shareholder may request conversion of the whole or part of his Shares of a given Class into Shares of the same

Class of another Fund, (or within one Fund into another Category) based on a conversion formula as determined from
time to time by the Board and disclosed in the current explanatory memorandum or prospectus of the Company provided
that the Board may impose such restrictions as to, inter alia, frequency of conversion, and may make conversion subject
to payment of such reasonable charge, as it shall determine and disclose in the current explanatory memorandum or
prospectus.

In the event that, for any reason, the value of the total net assets of any individual Fund, declines to, or fails to reach,

an amount determined by the Board to be the minimum appropriate level for the relevant Fund, or in the event that the
Board deems it appropriate because of changes in the economical or political situation affecting the relevant Fund, or
because it is in the best interests of the relevant shareholders, the Company may, by written notice to the Shareholders
of the relevant Fund redeem on the valuation day indicated in such written notice all (but not some) of the Shares of the
Fund at a price reflecting the anticipated realisation and liquidation costs of closing the relevant Fund, but without the
application of any redemption charge.

Termination of a Fund by compulsory redemption of all relevant Shares for reasons other than those mentioned in

the preceding paragraph, may be effected only upon its prior approval of the Shareholders of the Fund to be terminated,
at a duly convened Fund meeting which may be validly held without a quorum and decided by a simple majority of the
Shares present or represented.

Liquidation proceeds not claimed by the Shareholders at the close of the liquidation of a Fund will be deposited at the

Caisse de Consignation in Luxembourg. If not claimed, they shall be forfeited after 30 years.

The Board shall have the power, in accordance with the provisions of the 2010 Law, to merge a Fund with another

Fund of the Company or with another UCITS (whether established in Luxembourg or another Member State and whether
such UCITS is incorporated as a company or is a contractual type fund) or with a subfund of another such UCITS (the
“new sub-fund”). The Company shall send a notice to the Shareholders of the relevant Funds in accordance with the
provisions of CSSF Regulation 10-5. Every Shareholder of the relevant Funds shall have the opportunity of requesting the
redemption or the conversion of his own shares without any cost (other than the cost of disinvestment) during a period
of at least 30 days before the effective date of the merger, it being understood that the effective date of the merger takes
place within five business days after the expiry of such notice period.

A merger having as effect that the Company as a whole will cease to exist must be decided by the Shareholders of the

Company before notary. No quorum is required and the decision shall be taken at a simple majority of the Shareholders
present or represented and voting.”

<i>Seventh resolution

The shareholders of the Company RESOLVED to amend article 22 to add a paragraph i) providing that the subscriptions

and/or redemptions of Shares may be suspended in case of a merger of a Fund or of the Company and to add a paragraph

76497

L

U X E M B O U R G

h) providing that that the subscriptions and/or redemptions of Shares of a Fund that is a feeder fund may be suspended

in case of suspension of the subscriptions and/or redemptions of shares of the master fund, so that article 22 shall now
read as follows:

“The Net Asset Value of Shares in the Company shall be determined as to the Shares of each Fund by the Company

from time to time, but in no instance less than twice monthly, as the Board by regulation may direct (every such day or
time for determination thereof being a Dealing Day), but so that no day observed as a holiday by banks in Luxembourg
shall be a Dealing Day.

During the existence of any state of affairs which, in the opinion of the directors, makes the determination of the Net

Asset Value of a Fund in the relevant currency of expression either not reasonably practical or prejudicial to the Share-
holders of the Company, the Net Asset Value and the Subscription Price and Redemption Price may temporarily be
determined in such other currency as the directors may determine.

The Company may suspend the determination of the Net Asset Value and the issue and redemption of Shares in any

Fund as well as the right to convert Shares of any Fund into Shares of another Fund during:

(a) any period when any market or stock exchange which is the principal market or stock exchange on which a material

part of the investments of the Company of the relevant Fund for the time being are quoted, is closed (otherwise than for
ordinary holidays), or during which dealings are restricted or suspended;

(b) the existence of any state of affairs which in the opinion of the Board constitutes an emergency as a result of which

disposals or valuations of assets owned by the Company attributable to investments of the relevant Fund would be
impractical;

(c) any breakdown in - or restriction in the use of the means of communication normally employed in determining the

prices of any of the investments attributable to any Fund or the current price on any stock exchange; or

(d) any period when, for any other reason, the prices of any investments attributable to any Fund cannot be promptly

or accurately ascertained.

(e) any period when remittance of monies which will or may be involved in the realisation of or in the payment for

any of the Company's investments is not possible;

(f) in case of a decision to liquidate the Company or a Fund thereof on or after the day of publication of the first notice

convening the general meeting of Shareholders for this purpose respectively the notice provided for in Article 21, 11 

th

paragraph;

(g) the period following a determination by the Board that there has been a material change in the valuation of a

substantial proportion of the investments of any Fund, and that in order to safeguard the interests of Shareholders and
the Company, the preparation or use of a valuation may be delayed or substituted by a later or subsequent valuation;

(h) any period when in the opinion of the Board there exist circumstances beyond the control of the Board where it

would be impracticable, inappropriate or unfair towards the Shareholders to continue dealing in the Shares of all or any
particular Funds of the Company.

The Company may suspend the subscription and/or redemption of Shares:
(i) following a decision to merge a Fund or the Company, if justified with a view to protecting the interest of Share-

holders;

(j) in case a Fund is a Feeder of another UCITS (or a sub-fund thereof), if the Master UCITS (or the sub-fund thereof)

has suspended the subscription and/or redemption of its shares.

Shareholders having requested redemption or conversion of their Shares shall be notified of any such suspension within

seven days of their request and will be promptly notified of the termination of such suspension. Shares redeemed or
converted after such suspension will be converted or redeemed based on their Net Asset Value on the valuation day
immediately following such suspension.

The suspension as to any Fund will have no effect on the calculation of Net Asset Value and the issue, redemption and

conversion of the Shares of any other Fund.”

<i>Eighth resolution

The shareholders of the Company RESOLVED to amend article 25 by deleting the words “sent to registered Share-

holders and/or published and” in the last paragraph, so that the last paragraph of article 25 shall now read as follows:

“The accounts of the Company shall be expressed in US dollars or in respect of any Fund, in such other currency or

currencies as the Board may determine.

Where there shall be different Funds as provided for in Article 5 hereof, and if the accounts within such Funds are

maintained in different currencies, such accounts shall be converted into US dollars and added together for the purpose
of determination of the accounts of the Company. The annual accounts, including the balance sheet and profit and loss
account, the directors' report and the notice of the annual general meeting will be made available not less than 15 days
prior to each annual general meeting.”

76498

L

U X E M B O U R G

<i>Ninth resolution

The shareholders of the Company RESOLVED to amend article 27 by updating the name of T. Rowe Price Global

Investment Services Limited” to “T. Rowe Price International Ltd”, so that article 27 shall now read as follows:

“The Company shall enter into investment management agreements with "T. ROWE PRICE INTERNATIONAL LTD,

who, in turn, may sub-delegate the investment management to its affiliates, for the management of the assets of the
Company and assistance with respect to its portfolio selection. In the event of termination of said agreements in any
manner whatsoever, the Company will change its name forthwith upon the request of any such entity to a name omitting
the words "T. ROWE PRICE".”

<i>Tenth resolution

The shareholders of the Company RESOLVED to amend article 28 by replacing “Article 107 of the 2002 Law” by

“Article 146 of the 2010 Law” in the last paragraph, so that the last paragraph of article 28 shall now read as follows:

“With the consent of the Shareholders expressed in the manner provided for by Articles 67 1 and 142 of the 1915

Law, the Company may be liquidated and the liquidator authorised subject to giving one month's prior notice to the
Shareholders and by a decision by majority vote of two thirds of the Company's Shareholders to transfer all assets and
liabilities of the Company to a Luxembourg UCITS in exchange for the issue to the Shareholders in the Company of
shares of such UCITS in proportion to their shareholding in the Company. Otherwise any liquidation will entitle a sha-
reholder to a pro rata share of the liquidation proceeds corresponding to his Class of Shares. Moneys available for
distribution to Shareholders in the course of the liquidation that are not claimed by Shareholders will at the close of
liquidation be deposited at the Caisse des Consignations in Luxembourg pursuant to Article 146 of the 2010 Law, where
during 30 years they will be held at the disposal of the Shareholders entitled thereto.”

<i>Eleventh resolution

The shareholders of the Company RESOLVED to amend article 30 to replace the reference to “the 2002 Law” by a

reference to “the 2010 Law”, so that article 30 shall now read as follows:

“All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the Law of 10 

th

 August 1915 and

the 2010 Law.”

<i>Twelfth resolution

The shareholders of the Company RESOLVED that the restated Articles be solely drafted in English and not be followed

by a French translation.

There being no further item on the agenda the Chairman closed the meeting at 3 p.m..

Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames,

names, civil status and residences, the appearing persons signed together with the notary, the present original deed.

Signé: X. ROUVIERE, B. FLANAGAN, R. CARLETTI et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 11 juin 2014. Relation: LAC/2014/26946. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juin 2014.

Référence de publication: 2014085765/418.
(140100809) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2014.

Swedbank Robur International, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 31.868.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-fifth day of the month of March.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held

an extraordinary general meeting of shareholders (the "Meeting") of Swedbank Robur International Total Return Fixed

Income (the "Merging Fund"), a sub-fund of Swedbank Robur International (the "Company"), a société anonyme qualifying
as a société d'investissement à capital variable having its registered office at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
L-1331 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés of Lu-
xembourg under number B 31.868, incorporated on 25 October 1989 by deed of Maître Frank Baden, notary then residing

76499

L

U X E M B O U R G

in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the
"Mémorial"), number 350 of 28 November 1989.

The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time on 3 June 2011, by deed of Maître

Carlo Wersandt, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of Maître Henri Hellinckx, notary residing in
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial, number 2454 of 12 October 2011.

The Meeting is opened by Mr Björn Möller, employee, professionally residing in Luxembourg in the chair (the “Chair-

man”).

The Chairman appoints as secretary Mr Philip Sahlin, employee, professionally residing in Luxembourg.
The Meeting elects as scrutineer Yannick Loutsch, employee, professionally residing in Luxembourg.
The bureau of the Meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to record

that:

I. All the shares being registered shares, the Meeting was convened by notices containing the agenda sent to every

shareholder of the Merging Fund by registered mail on 14 March 2014.

II. The shareholders present or represented at the Meeting and the number of shares held by each of them are shown

on an attendance list signed by the shareholders present, the proxies of the represented shareholders, the Chairman, the
secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said attendance list and proxies initialled "ne varietur" by the
members of the bureau and the undersigned notary will be annexed to this document, to be registered with this deed.

III. In order to validly deliberate on the agenda, a quorum of 50% per cent of the Merging Fund’s capital is required

and decisions are taken by a majority of two thirds of the votes cast.

IV. It appears from the attendance list that more than 50% per cent of the Merging Fund’s capital is present or repre-

sented at the Meeting.

V. The sole item on the agenda of the Meeting is the following:
To approve, on the basis of the common merger proposal, the merger of Swedbank Robur International Total Return

Fixed Income Sub Fund, sole remaining active sub-fund in the Company, into Swedbank Robur Räntefond Flexibel, a
common fund also managed by Swedbank Robur Fonder AB (a company incorporated under the laws of Sweden, having
its registered office at Malmskillnadsgatan 32, 105 34 Stockholm, Sweden, registered with the Swedish Companies Re-
gistration  Office  under  registration  number  556198-0128  and  authorised  as  a  fund  management  company  by  the
Finansinspektionen in accordance with the Act (2004:46) on Securities Funds) and qualifying as a UCITS pursuant to the
Act (2004:46) on Securities Funds, with effect on 12 June 2014, as a consequence of which the Company will cease to
exist.

It results from the foregoing that the Meeting is regularly constituted and may validly deliberate on the sole item of

the agenda.

Then the Meeting takes the following resolution:

<i>Sole resolution

The Meeting resolves with 153,204,808 votes in favour, 0 votes against and 0 abstentions to approve, in accordance

with the provisions of the common merger proposal, the merger of Swedbank Robur International Total Return Fixed
Income Sub Fund, sole remaining active sub-fund in the Company into, Swedbank Robur Räntefond Flexibel, a common
fund managed by Swedbank Robur Fonder AB and qualifying as a UCITS pursuant to the Act (2004:46) on Securities
Funds.

In accordance with Article 66 (4) of the amended law of 17 December 2010 on undertakings for collective investment,

the undersigned notary records in this deed 12 June 2014 as the effective date of the merger of Swedbank Robur Inter-
national Total Return Fixed Income Sub Fund, sole remaining active sub-fund in the Company, into Swedbank Robur
Räntefond Flexibel, a common fund managed by Swedbank Robur Fonder AB and qualifying as a UCITS pursuant to the
Act (2004:46) on Securities Funds, as a consequence of which the Company will cease to exist.

All the books and records of the Company will be kept during a period of five years at the former registered office of

the Company at L-1331 Luxembourg, 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

The appearing persons and the undersigned notary noted that the French translation of the present deed is not required

in accordance with article 26 (2) of the amended law of 17 December 2010 on undertakings for collective investment
and that therefore no French translation of the present deed will follow the English version.

There being no further business on the agenda, the Meeting is thereupon closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing persons,

the present deed is worded in English.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, the members of the bureau signed together with the notary

the present deed.

Signé: P. SAHLIN, Y. LOUTSCH, B. MÖLLER et H. HELLINCKX.

76500

L

U X E M B O U R G

Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 avril 2014. Relation: LAC/2014/15481. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juin 2014.

Référence de publication: 2014077276/76.
(140090996) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2014.

Santander SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2632 Luxembourg, 6, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 45.337.

In the year two thousand and fourteen,
on the thirtieth day of the month of May.
Before Us, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in SANEM, Grand Duchy of Luxembourg,

was held

an extraordinary general meeting of the shareholders (the "Meeting") of SANTANDER SICAV, a société anonyme

qualifying as a société d'investissement à capital variable, having its registered office at 28-32, place de la Gare, L-1616
Luxembourg and registered under R.C.S. Luxembourg B 45.337 (the "Corporation"). The Corporation was incorporated
pursuant to a notarial deed enacted on 27 October 1993, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
(the "Mémorial"), number 564 on 27 November 1993. The articles of association of the Corporation (the "Articles")
were last amended on 31 May 2013 pursuant to a notarial deed, published in the Mémorial C, number 1428 on 17 June
2013.

The Meeting was declared open at 10.00 a.m. and was presided over by Ms Marie MAGONET, employee, professionally

residing in Luxembourg (the “Chairman”).

The Chairman appointed as secretary Ms Catherine BODELET, employee, professionally residing in Luxembourg.
The Meeting appointed as scrutineer Ms Karine NARDINI, employee, professionally residing in Luxembourg.
The board of the Meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the Meeting is the following:

<i>Agenda

<i>Sole resolution

Amendment of the articles of incorporation of the Corporation (the "Articles") in order to:
1. Change the registered office of the Corporation within the Grand Duchy of Luxembourg from Luxembourg City

to Senningerberg with effect as from 2 June 2014 and consequently amend article 4 of the Articles.

2. Amend article 24 of the Articles to clarify the net asset value calculation process.
II. That the shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number

of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders present, the proxyholders
of the represented shareholders and by the members of the Board, will remain annexed to the present deed to be filed
at the same time with the registration authorities.

III. That all the shares outstanding are registered shares and that the shareholders have been informed of the present

Meeting by a convening notice sent by registered mail on 16 May 2014.

IV. It appears from the attendance list that, out of the eighteen million hundred seventy-seven thousand seven hundred

fifty-three (18’177’753) shares in issue, twelve million thirty-one thousand nine hundred thirty (12’031’930) shares are
represented at the Meeting.

V. That, as a result of the foregoing, the present Meeting is regularly constituted and may validly deliberate on the

following resolutions:

<i>Sole resolution

The shareholders decided with twelve million thirty-one thousand nine hundred thirty (12,031,930) votes in favour,

no votes against and no abstentions to:

1. - transfer the registered office of the Corporation within the Grand Duchy of Luxembourg from Luxembourg-City

to 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg;

- consequently amend article 4 of the Articles so as to read as follows:

"  Art. 4.  The  registered  office  of  the  Corporation  is  established  in  Senningerberg,  Grand  Duchy  of  Luxembourg.

Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the Board of Directors.

76501

L

U X E M B O U R G

If permitted by and under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the Board of Directors may

transfer the registered office of the Corporation to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg.

In the event that the Board of Directors determines that extraordinary political, economic, social or military deve-

lopments  have  occurred  or  are  imminent  that  would  interfere  with  the  normal  activities  of  the  Corporation  at  its
registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may
be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary mea-
sures shall have no effect on the nationality of the Corporation which, notwithstanding the temporary transfer of its
registered office, will remain a Luxembourg corporation."

2. to amend: the following paragraphs of article 24 of the Articles so as to read as follows:

First paragraph. "The Net Asset Value of Shares of each Category in each Class of Shares shall be expressed as a per

Share figure in the currency of the relevant Category of Shares as determined by the Board and shall be determined in
respect of any Valuation Day by dividing the net assets of the relevant Class corresponding to such Category, being the
value of the assets of the relevant Class attributable to such Category less its liabilities attributable to such Category at
such time or times as the Board of Directors may determine, by the number of shares of the relevant Category then
outstanding and by rounding up or down to such decimals as the Board of Directors may decide and as further disclosed
in the sales documents of the Corporation."

Paragraph B. relating to the liabilities of the Company, point d):
d) all other liabilities of the Corporation of whatsoever kind and nature except liabilities represented by shares in the

Corporation. In determining the amount of such liabilities the Corporation shall take into account all expenses payable
by the Corporation comprising (without any limitation) formation expenses, fees payable to its investment advisers or
investment managers, accountant, custodian, administrative, domiciliary, registrar and transfer agents, paying agents and
permanent representatives in places of registration, any other delegate, agent or employee of the Corporation, fees for
legal and auditing services, stock exchange listing costs, promotional, printing, reporting and publishing expenses, including
the cost of advertising or preparing and printing of certificates, prospectuses, explanatory memoranda or registration
statements, taxes or governmental charges, and all other operating expenses, including the cost of buying and selling
assets, insurance premium, interest, bank charges and brokerage, postage, telephone and telex.

The Meeting noted that the French translation of the Articles is not required anymore in accordance with Article 26

(2) of the 2010 Law and therefore no French translation of this deed will follow the English version.

Nothing else being on the agenda and no other person wished to speak, the Chairman closed the Meeting at The

undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing persons,
the present deed is worded in English only in accordance with Article 26 (2) of the 2010 Law.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the date named at the beginning of this document.
The document having been read to the parties appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the members of the Bureau signed together with Us, the notary, the present
original deed, no shareholder expressing the wish to sign.

Signé: M. MAGONET, C. BODELET, K. NARDINI, J.-J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 3 juin 2014. Relation: EAC/2014/7757. Reçu soixante-quinze Euros (75,- EUR).

<i>Le Receveur ff.

 (signé): Monique HALSDORF.

Référence de publication: 2014084116/87.
(140098875) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2014.

Genesta Nordic Capital Fund Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Genesta Property Nordic Luxembourg Sarl).

Capital social: EUR 125.000,00.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 50, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 150.632.

L'an deux mille quatorze, le vingt-huit mai.
Par-devant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

A COMPARU:

«Genesta Property Nordic AB», une private limited company constituée et existant selon les lois du Royaume de

Suède, avec siège social à SE-111 44 Stockholm (Suède), 16, Jakobsbergsgatan (Suède), immatriculée au Swedish Com-
panies Registration Office sous le numéro 556630-6089 (ci-après la «comparante»),

ici représentée par Maître Nadia BONNET, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-2082 Luxembourg,

14, rue Erasme,

en vertu d’une procuration délivrée sous seing privé, donnée le 24 mars 2014,

76502

L

U X E M B O U R G

laquelle procuration, paraphée «ne varietur» par la mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, restera

annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux fins d’enregistrement.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi

qu'il suit les déclarations et constatations suivantes:

-  que  la  société  à  responsabilité  limitée  de  droit  luxembourgeois  «Genesta  Nordic  Capital  Fund  Management  S.à

r.l.» (anciennement «Genesta Property Nordic Luxembourg S.à r.l.»), avec siège social à L-1660 Luxembourg, 50, Grand-
Rue, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 150.632, ayant
un capital social de cent vingt-cinq mille euros (EUR 125.000,00), a été constituée suivant acte reçu par Maître Henri
HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 28 décembre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 325 du 15 février 2010, et que les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le
notaire instrumentant en date du 17 juillet 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
1883 du 5 août 2013,

- que suite à une erreur matérielle au prédit acte du 17 juillet 2013, la deuxième résolution prise par l’assemblée

générale concernant la description des modalités de l’augmentation de capital et des montants des profits convertis, doit
se lire dans ses versions en langue anglaise et française comme suit:

- Version en langue anglaise:

<i>“Second resolution:

The meeting decides to increase the company's share capital by an amount of one hundred and twelve thousand five

hundred Euro (EUR 112,500.-) so as to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR
12,500.-) to one hundred twenty five thousand Euro (EUR 125,000.-), by the creation and issue of nine hundred (900)
new shares, having a nominal value of one hundred and twenty-five Euro (EUR 125.-) each, bearing the same rights and
obligations than the existing shares, by a conversion of profits amounting to ninety-one thousand five hundred ninety-six
euro and eleven eurocents (EUR 91,596.11) and interest free shareholders’ advances amounting to twenty thousand nine
hundred three euro and eighty-nine euro cents (EUR 20,903.89), as results from the balance sheet as of 30 June 2013,
duly approved by the circular resolutions of the sole shareholder taken with effect as of 10 July 2013.

The independent auditor’s report including the balance sheet of the company as of 30 June 2013, and dated on 11

March 2014, after being signed “ne varietur”, shall remain attached to the deed in order to be filed with it.

Thereupon, the sole shareholder subscribed all nine hundred (900) new shares.”

- Version en langue française:

<i>«Deuxième résolution:

L’assemblée décide d’augmenter le capital social de la société d’un montant de cent douze mille cinq cents euros (EUR

112.500,-) afin de le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à cent vingt-cinq mille
euros (EUR 125.000,-), par la création et l’émission de neuf cents (900) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale
de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes, par
une conversion en capital de bénéfices à hauteur de quatre-vingt-onze mille cinq cent quatre-vingt-seize euros et onze
cents (EUR 91.596,11) et d’une avance d’associés ne portant pas d’intérêts à hauteur de vingt mille neuf cent trois euros
et quatre-vingt-neuf cents (EUR 20.903,89), tel qu'ils résultent du bilan de la société arrêté au 30 juin 2013, dûment
approuvé par les résolutions circulaires prises par l’associé unique avec effet au 10 juillet 2013.

Le rapport du Réviseur d’entreprises agréé (independent auditor’s report) incluant le bilan de la société au 30 juin

2013, et daté du 11 mars 2014, après avoir été paraphé «ne varietur», restera annexé au présent acte pour être formalisé
avec celui-ci.

Ensuite, l’associé unique souscrit à l’ensemble des neuf cents (900) nouvelles parts sociales.»

<i>Annexe

Le rapport du Réviseur d’entreprises agréé (independent auditor’s) incluant le bilan de la société au 30 juin 2013, et

daté du 11 mars 2014, après avoir été paraphé «ne varietur», restera annexé au présent acte pour être formalisé avec
celui-ci.

<i>Constatation

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande de la partie comparante le présent acte

est rédigé en langue française suivi d'une version en langue anglaise, et que sur demande de la même partie comparante
et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Après lecture faite des présentes au mandataire de la partie comparante, connue du notaire instrumentant par nom,

prénom usuel et demeure, cette personne a signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: N. BONNET, E. SCHLESSER.

76503

L

U X E M B O U R G

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 30 mai 2014. Relation: LAC/2014/25192. Reçu douze-euros (12,- €).

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 juin 2014.

Référence de publication: 2014083754/76.
(140099491) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2014.

Thorp S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 138.724.

In the year two thousand and fourteen, the sixth day of June, before Me Henri BECK, notary residing in Echternach,

Grand Duchy of Luxembourg,

was held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Thorp S.à r.l. in liquidation, a Luxembourg

private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 20, rue de la Poste, L-2346
Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under the number B 138.724 and
having a share capital of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) (the Company). The Company was incorpo-
rated pursuant to a deed enacted by Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
on 14 May 2008 published on 12 June 2008 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, under number 1459,
page 69995. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended for the last time by a deed of
Me Henri Beck, notary residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg dated 30 December 2013, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 415, page 19885, dated 14 February 2014.

THERE APPEARED:

Stark Select Asset Master Ltd., a limited partnership incorporated under the laws of the British Virgin Islands, having

its registered office at Craigmuir Chamber Road Town, BVI - Tortola, British Virgin Islands and registered with the British
Virgin Islands chamber of commerce under number 1527252 (the Sole Shareholder),

hereby represented by Peggy Simon, private employee, residing professionally in Echternach, 9, Rabatt, by virtue of a

power of attorney given under private seal.

Said power of attorney, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party

and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration
authorities.

The Sole Shareholder, represented as stated above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. that the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company;
II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. waiver of convening notices;
2. presentation of the report of the liquidation auditor (commissaire);
3. discharge (quitus) to the managers of the Company for all their duties during, and in connection with their mandate;
4. discharge (quitus) to Stark Select Asset Master Ltd., as liquidator (liquidateur) of the Company for all its duties

during, and in connection with, the voluntary liquidation (liquidation volontaire) of the Company;

5. discharge (quitus) to Stark Entity Services LLC, as liquidation auditor (commissaire) of the Company for all its duties

during, and in connection with, the voluntary liquidation (liquidation volontaire) of the Company;

6. decision to close the liquidation of the Company;
7. decision that the Company’s documents and books be kept for five (5) years from the date of publication of the

closing of the liquidation in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, at the following address: 20, Rue de la
Poste, L-2346 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

8. granting of proxies; and
9. miscellaneous.
III. After having carefully considered the above, the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder declares that he has full knowledge of the items on the agenda and waives the requirement for

convocations.

76504

L

U X E M B O U R G

<i>Second resolution

The Sole Shareholder acknowledges and approves the report of Stark Entity Services LLC, appointed as liquidation

auditor (commissaire) of the Company pursuant to resolutions of the Company’s shareholder dated 14 May, 2014, on
the good performance of the actions taken and the liquidation report (rapport de liquidation) presented by Stark Select
Asset Master Ltd., appointed as liquidator (liquidateur) of the Company by the extraordinary general meeting of the
shareholder of the Company held on 30 December 2013 (the Liquidator) during the voluntary liquidation (liquidation
volontaire) of the Company.

The liquidation auditor informs the Sole Shareholder that all the liabilities of the Company have been settled or provided

for and that all the remaining assets of the Company have been paid so that the Company can be liquidated and that the
liquidation may therefore be closed.

The liquidation auditor confirms that the Liquidator has completed his mission with due care, that the Liquidator has

acted in the best interest of the Company.

<i>Third resolution

After having acknowledged the liquidation auditor’s report, the Sole Shareholder resolves to approve the Liquidator’s

report and the liquidation accounts dated 30 December 2013.

<i>Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves to give discharge (quitus) to all managers of the Company for the performance of all

their duties during and in connection with, their mandate.

<i>Fifth resolution

The Sole Shareholder resolves to give discharge (quitus) to Stark Select Asset Master Ltd., as Liquidator of the Company

for the performance of all his duties during, and in connection with, the voluntary liquidation (liquidation volontaire) of
the Company.

<i>Sixth resolution

The Sole Shareholder resolves to give discharge (quitus) to Stark Entity Services LLC, as liquidation auditor (commis-

saire) of the Company for the performance of all his duties during, and in connection with, the voluntary liquidation
(liquidation volontaire) of the Company.

<i>Seventh resolution

After considering that the existing assets of the Company have all been distributed to the Sole Shareholder of the

Company and that no liquidation proceeds are outstanding, and thus that no further distributions shall be made to the
shareholder of the Company, the Sole Shareholder resolves to close the liquidation as per the date of the present Meeting.

All expenses and outstanding liabilities related to this liquidation will be borne by the Sole Shareholder.

<i>Eighth resolution

The Sole Shareholder resolves to set the place where the Company’s documents and books are to be kept during five

(5) years from the date of publication of the closing of the liquidation in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,
C at the following address: 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

<i>Ninth resolution

The Sole Shareholder resolves to give full power of attorney to any lawyer of Loyens &amp; Loeff Luxembourg S.à r.l. and

any employee of Citco REIF Services (Luxembourg) S.A., to file, register with the competent authorities any documents,
deeds, articles, instruments, agreements, notices, acknowledgments, statements, certificates, or any other document as
may be necessary or useful in connection with the liquidation of the Company, including but not limited to any outstanding
tax returns as well as the performance by the Company of the obligations contained therein.

<i>Costs

The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at approximately eight hundred fifty Euro (EUR 850.-).

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Echternach, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party

signed together with us, the notary, the present original deed.

76505

L

U X E M B O U R G

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatorze, le sixième jour du mois de juin, par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à

Echternach, Grand-Duché de Luxembourg,

s’est tenue

une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) de l’associé unique de Thorp S.à r.l. en liquidation, une société

à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 138.724 et ayant un capital
social de douze mille cinq cents euro (EUR 12.500,-) (la Société). La Société a été constituée suivant acte de Maître Henri
Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 14 mai 2008, publié le 12 juin
2008 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, sous le numéro 1459, page 69995. Les statuts de la Société
(les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte de Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach,
Grand-Duché de Luxembourg, en date du 30 décembre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
sous le numéro 415, page 19885, le14 février 2014.

A COMPARU:

Stark Select Asset Master Ltd., une société en commandite constituée selon les lois des Îles Vierges Britanniques, ayant

son siège social situé à Craigmuir Chambers Road Town, BVI, Tortola, Îles Vierges Britanniques et immatriculée auprès
de la chambre de commerce des Îles Vierges Britanniques, sous le numéro 1527252 (l’Associé Unique),

représenté par Peggy Simon, employée privée, avec adresse professionnelle à Echternach, 9, Rabatt, en vertu d’une

procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante

et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d’être soumise avec celui-ci aux formalités de l’enre-
gistrement.

L’Associé Unique a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. que l’Associé Unique représenté à l’Assemblée détient toutes les parts sociales dans le capital social de la Société;
II. que l’ordre du jour de l’Assemblée est libellé de la manière suivante:
1. renonciation aux formalités de convocation;
2. présentation du rapport du commissaire;
3. décharge (quitus) aux gérants de la Société pour l’exécution des toutes leurs fonctions pendant, et en relation avec,

leur mandat;

4. décharge (quitus) à Stark Select Asset Master Ltd. en tant que liquidateur de la Société pour l’exécution de toutes

ses fonctions pendant, et en relation avec, la liquidation volontaire de la Société;

5. décharge (quitus) à Stark Entity Services LLC en tant que commissaire de la Société pour l’exécution de toutes ses

fonctions pendant, et en relation avec, la liquidation volontaire de la Société;

6. décision de clôturer la liquidation de la Société;
7. décision de fixer le lieu où les livres et documents sociaux de la Société seront conservés pendant cinq (5) ans à

compter de la date de publication de la clôture de la liquidation au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C, à
l’adresse suivante: 20, Rue de la Poster, L-2346 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

8. octroi de pouvoirs; et
9. divers.
III. Après avoir soigneusement examiné ce qui précède, l’Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Associé Unique déclare avoir pris connaissance de l’ordre du jour et renonce aux formalités de convocation.

<i>Deuxième résolution

L’Associé Unique décide de prendre acte et d’approuver le rapport de Stark Entity Services LLC, nommé commissaire

de la Société par résolutions écrites de l’actionnaire de la Société du 14 mai 2014 sur la bonne exécution des actions
entreprises et le rapport de liquidation présenté Stark Select Asset Master Ltd., nommé liquidateur de la Société par
l’assemblée générale extraordinaire de l’associé de la Société tenue 30 décembre 2013 (le Liquidateur) au cours de la
liquidation volontaire de la Société.

Le commissaire informe l’Associé Unique que toutes les dettes de la Société ont été réglées ou prévues et que tous

les actifs restants de la Société ont été payés afin que la Société puisse être liquidée et que la liquidation puisse être ainsi
clôturée.

Le commissaire confirme que le Liquidateur a rempli sa mission avec diligence et qu’il a agi dans le meilleur intérêt de

la Société.

76506

L

U X E M B O U R G

<i>Troisième résolution

Après avoir pris acte du rapport du commissaire, l’Associé Unique décide d’approuver le rapport du Liquidateur ainsi

que les comptes de liquidation datés du 30 décembre 2013.

<i>Quatrième résolution

L’Associé Unique décide de donner décharge (quitus) à tous les gérants de la Société pour l’exécution de toutes leurs

fonctions pendant, et en relation avec, leur mandat.

<i>Cinquième résolution

L’Associé Unique décide d’accorder décharge (quitus) à Stark Select Asset Master Ltd. en tant que Liquidateur de la

Société pour l’exécution de ses fonctions pendant, et en relation avec, la liquidation volontaire de la Société.

<i>Sixième résolution

L’Associé Unique décide d’accorder décharge (quitus) à Stark Entity Services LLC en tant que commissaire de la Société

pour l’exécution de ses fonctions pendant, et en relation avec, la liquidation volontaire de la Société.

<i>Septième résolution

Tous les actifs restants de la Société ayant été distribués à l’Associé Unique de la Société et aucun boni de liquidation

n’étant en suspens, de sorte que plus aucune distribution ne sera faite à l’associé de la Société, l’Associé Unique décide
de clôturer la liquidation à la date de la présente Assemblée.

Toutes les dépenses et dettes éventuelles en rapport avec la liquidation seront prises en charge par l’Associé Unique.

<i>Huitième résolution

L’Associé Unique décide de fixer le lieu où les livres et documents sociaux de la Société seront conservés pendant

cinq (5) ans à compter de la date de publication de la clôture de la liquidation au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations, C, à l’adresse suivante: 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

<i>Neuvième résolution

L’Associé Unique décide de donner pouvoir à tout avocat de Loyens &amp; Loeff Luxembourg S.à r.l. ainsi qu’à tout employé

de Citco REIF Services (Luxembourg) S.A. afin de déposer, enregistrer auprès des autorités compétentes tous documents,
actes, articles, instruments, contrats, avis, reconnaissances, déclarations, certificats, ou tous autres documents pouvant
être nécessaires ou utiles en relation avec la liquidation de la Société, en ce compris mais non limité à toutes déclarations
fiscales en suspens ainsi que l’exécution par la Société des formalités y relatives.

<i>Frais

Les dépenses, frais et rémunérations et charges qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte sont

estimés à environ huit cent cinquante Euros (EUR 850.-).

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur demande de la partie comparante, le présent acte

est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. A la demande de la même partie comparante et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Echternach, date qu’en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé le présent acte

avec le notaire.

Signé: P. SIMON, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 10 juin 2014. Relation: ECH/2014/1094. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

Echternach, le 13 juin 2014.

Référence de publication: 2014084166/196.

(140098782) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2014.

76507

L

U X E M B O U R G

PG Investments International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5818 Alzingen, 22, rue du Cimetière.

R.C.S. Luxembourg B 186.174.

STATUTS

L'an deux mille quatorze, le dix avril.
Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

Monsieur Pierre GIRAULT, administrateur de sociétés, demeurant à L-5818 Alzingen, 22, rue du Cimetière.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'il déclare

constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

Titre I 

er

 . Dénomination - Siège social - Objet Durée - Capital social

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de «PG INVESTMENTS INTERNATIONAL S.A.».

Art. 2. Le siège social est établi à Alzingen.
Il pourra être transféré en tout autre endroit de la commune par simple décision du conseil d'administration respec-

tivement de l'administrateur unique.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anor-
males.

Une telle décision n'aura pas d'effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 3. La durée de la société est indéterminée.

Art. 4. La société a pour objet, directement ou indirectement, tant à Luxembourg qu'à l'étranger:
La prise de participations sous quelque forme que ce soit, par achat, échange ou de toute autre manière, dans d'autres

entreprises et sociétés luxembourgeoises ou étrangères ainsi que la gestion, le contrôle, la mise en valeur de ces parti-
cipations. La société peut également procéder au transfert de ces participations par voie de vente, échange ou autrement.

La société peut emprunter sous toute forme notamment par voie d'émission d'obligations, convertibles ou non, de

prêt bancaire ou de compte courant actionnaire, et accorder à d'autres sociétés dans lesquelles la société détient ou non
un intérêt direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle peut s'intéresser à toutes valeurs mobilières, dépôts d'espèces, certificats de trésorerie, et toute autre forme de

placement dont notamment des actions, obligations, options ou warrants, les acquérir par achat, souscription ou toutes
autres manières, les vendre ou les échanger.

La société peut acquérir et vendre des biens immobiliers, ou des droits immobiliers, soit au Grand-Duché de Luxem-

bourg soit à l'étranger ainsi que toutes les opérations liées à des biens immobiliers, ou des droits immobiliers, comprenant
la prise de participations directes ou indirectes dans des sociétés au Luxembourg ou à l'étranger dont l'objet principal
consiste dans l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers, ou
de droits immobiliers.

La société a également pour objet la détention, l'achat, la mise en valeur, l'exploitation et la vente de toutes propriétés

intellectuelles luxembourgeoises et étrangères, certificats d'addition et brevets de perfectionnement, méthodes, procé-
dés, inventions, marques de fabrique, franchises, moyens de fabrication et la concession de toutes licences totales ou
partielles des dites propriétés intellectuelles.

En outre, elle peut faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières qui se

rattachent directement ou indirectement, en tout ou partie, à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en

association en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.

D'une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toutes

opérations qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet; elle pourra également détenir des mandats
d'administration d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, rémunérés ou non.

Art. 5. Le capital social est fixé à TRENTE-ET-UN MILLE EUROS (EUR 31.000) représenté par CENT (100) actions

sans désignation de valeur nominale.

76508

L

U X E M B O U R G

La société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle

que modifiée (la "Loi"), racheter ses propres actions.

Par ailleurs, la Société dispose d'un capital autorisé de cinq cent mille euros (EUR 500.000,-), en vertu duquel le conseil

d'administration est autorisé, pendant une période expirant le cinquième anniversaire de la publication du présent acte
de modifier les présents statuts au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, à émettre en une ou plusieurs fois,
le cas échéant sans réserver le droit préférentiel de souscription des actionnaires existants de la société, un maximum
de cinq mille actions (5.000) sans désignation de valeur nominale.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises avec ou sans prime d'émission ainsi qu'il sera déterminé

par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

A la suite de chaque émission d'actions réalisée dans le cadre du capital autorisé tel que défini ci-dessus, le conseil

d'administration veillera à faire constater l'augmentation du capital social de la société et la modification corrélative de
l'article 5 des présents statuts par acte notarié dans les délais prévu par la Loi.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne

dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme adapté à la modification intervenue.

Art. 6. Les actions de la société sont nominatives, sauf dispositions contraires de la Loi.
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui contiendra les indications prévues par l'article 39 de la Loi. La propriété des actions nominatives s'établit par une
inscription sur ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés par deux (2) adminis-
trateurs ou, si la société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.

La société pourra émettre des certificats représentatifs d'actions au porteur. Les actions au porteur porteront les

indications prévues par l'article 41 de la Loi et seront signées par deux (2) administrateurs ou, si la société ne comporte
qu'un seul administrateur, par celui-ci.

La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.
Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration.

En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant
pas partie du conseil d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§ 1 et 2 de la Loi.

La société ne reconnaît qu'un (1) propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse,

les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour présenter l'action à l'égard de
la société.

La société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été

désignée comme étant à son égard propriétaire.

Titre II. Administration - Surveillance

Art. 7. En cas de pluralité d'actionnaires, la société doit être administrée par un conseil d'administration composé de

trois membres au moins, actionnaires ou non.

Si la société est établie par un actionnaire unique ou si, à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est

constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d'administration peut être limitée
à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs ou l'administrateur unique seront élus par l'assemblée des actionnaires pour un terme qui ne peut

excéder six ans et toujours révocables par elle.

Les administrateurs sortants peuvent être réélus.
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et, s'il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents

du conseil d'administration. Le premier président sera désigné par l'assemblée générale. En cas d'absence du président,
les réunions du conseil d'administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.

Art. 8. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses membres.
Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d'administration. Sauf le cas d'urgence

qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins quinze jours avant la date fixée pour la réunion.

Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou vala-

blement représentés.

76509

L

U X E M B O U R G

Les réunions du conseil d'administration se tiennent au lieu et à la date indiquée dans la convocation.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou valablement représentée. La présence peut également être assurée par téléphone ou vidéo conférence.

Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et

pour voter en ses lieu et place.

Les résolutions du conseil seront prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside

la réunion sera prépondérante.

Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises lors

d'un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des copies
multiples d'une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes, télex ou fax.

Un administrateur ayant des intérêts personnels opposés à ceux de la société dans une affaire soumise à l'approbation

du conseil, sera obligé d'en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal de
la réunion. Il ne peut prendre part aux délibérations afférentes du conseil.

Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les

actionnaires seront informés des matières où un administrateur a un intérêt personnel opposé à celui de la société.

Au cas où un membre du conseil d'administration a dû s'abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à la majorité

des membres du conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables.

Lorsque la société comprend un administrateur unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opé-

rations intervenues entre la société et son administrateur ayant eu un intérêt opposé à celui de la société.

Art. 9. Les décisions du conseil d'administration seront constatées par des procès-verbaux qui seront insérés dans un

registre spécial et signé par au moins un administrateur.

Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signées par le président du conseil d'administration ou par deux

administrateurs ou l'administrateur unique.

Art. 10. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique sont investis des pouvoirs les plus étendus pour ac-

complir tous actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la Loi, telle que modifiée, ou par les statuts de la société

à l'assemblée générale, seront de la compétence du conseil d'administration ou de l'administrateur unique.

Art. 11. Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Le conseil d'admi-

nistration ou l'administrateur unique peut désigner des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout
temps. Le conseil d'administration peut également déléguer la gestion journalière de la société à un de ses membres, qui
portera le titre d'administrateur-délégué.

Art. 12. Le conseil d'administration pourra instituer un comité exécutif, composé de membres du conseil d'adminis-

tration et fixer le nombre de ses membres. Le comité exécutif pourra avoir tels pouvoirs et autorité d'agir au nom du
conseil d'administration que ce dernier aura déterminé par résolution préalable. A moins que le conseil d'administration
n'en dispose autrement, le comité exécutif établira sa propre procédure pour la convocation et la tenue de ses réunions.

Le conseil d'administration fixera, s'il y a lieu, la rémunération des membres du comité exécutif.

Art. 13. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique représente la société en justice, soit en demandant, soit

en défendant.

Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.

Art. 14. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée, en toutes circonstances par la signature individuelle de l'adminis-

trateur unique, ou suivant l'hypothèse d'une pluralité d'administrateurs, par la signature de l'administrateur-délégué ou
les signatures conjointes de deux administrateurs ou par la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites
de ses pouvoirs, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et
mandats conférés par le conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article 11 des statuts.

Art. 15. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, associés ou non, nommés pour une

durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Titre III. Assemblée Générale

Art. 16. S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés par l'assemblée des

actionnaires et prend les décisions par écrit.

En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la société.
Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales.
Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la Loi.

76510

L

U X E M B O U R G

Art. 17. L'assemblée générale statutaire se réunit au siège de la société ou à l'endroit indiqué dans les convocations,

le troisième lundi de mai à quatorze heures de chaque année. Si ce jour est un jour férié, l'assemblée est reportée au
premier jour ouvrable suivant.

Les assemblées générales, même l'assemblée annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que se produiront

des circonstances de force majeure qui seront souverainement appréciées par le conseil d'administration respectivement
par l'administrateur unique.

Le conseil d'administration respectivement l'administrateur unique fixera les conditions requises pour prendre part

aux assemblées générales.

Art. 18. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.

Art. 19. Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la Loi.

Titre IV. Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 20. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

Art. 21. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pourcent (5%) à la formation ou à l'alimentation du fond de

réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve atteint dix pourcent (10%) du capital

nominal.

L'assemblée générale décide souverainement de l'affectation du solde.
Le conseil d'administration ou l'administrateur unique est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se con-

formant aux conditions prescrites par la Loi.

Titre V. Dissolution - Liquidation

Art. 22. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale statuant suivant les

modalités prévues pour les modifications des statuts.

Art. 23. Lors de la dissolution de la société, l'assemblée générale règle le mode de liquidation, nomme un ou plusieurs

liquidateurs et détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VI. Disposition générale

Art. 24. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties déclarent se référer et se soumettre aux

dispositions de la Loi et à ses modifications ultérieures.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2014.
La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l'an 2015.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, Monsieur Pierre GIRAULT précité, déclare souscrire à toutes les CENT

(100) actions.

Toutes les actions ont été partiellement libérées à hauteur de 25,16% par des versements en espèces, de sorte que la

somme de SEPT MILLE HUIT CENTS EUROS (EUR 7.800,00) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société,
ainsi qu'il en est justifié au notaire instrumentaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par les articles 26, 26-3 et 26-5 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de EUR 1.200.-

<i>Décisions de l'actionnaire unique

Le comparant pré-mentionné, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes:
1.- Est nommé, en qualité d'administrateur unique et de Président:
- Monsieur Pierre GIRAULT, précité.
2.- Est nommé commissaire aux comptes:

76511

L

U X E M B O U R G

EXPERTISE TAMINO S.A., ayant son siège social au 21-25 allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, RCS Luxembourg B

87646.

3.- Le mandat de l'administrateur unique prendra fin à la suite de la tenue de l'assemblée générale ordinaire de 2019.
4.- Le mandat du commissaire prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire de 2019.
5.- Le siège social est établi à L-5818 Alzingen, 22, rue du Cimetière.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, il a signé le présent acte

avec le notaire.

Signé: P. GIRAULT et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 11 avril 2014. Relation: LAC/2014/17393. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur ff.

 (signé): C. FRISING.

- POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 16 avril 2014.

Référence de publication: 2014054844/227.
(140062693) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2014.

Lion/Gem Luxembourg 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.054.295,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 140.337.

<i>Extrait des résolutions de l'associé unique

En date du 8 avril 2014, l'associé unique de la société, Martin 1 Luxembourg, a décidé de transférer le siège social de

la société du 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg et ce avec
effet immédiat.

Nous vous prions de bien vouloir prendre note des changements suivants:
- L'adresse professionnelle des gérants A James HILL et William SHOWALTER a changé du 18, Soho Square, W1D

3QL Londres, Royaume-Uni, au 1 

st

 Floor, 77 Kingsway, WC2B 6SR Londres, Royaume-Uni;

- L'adresse professionnelle du gérant A Sanjay K. MOREY a changé de 8, Sloane Court East, SW3 4TF, Londres,

Royaume-Uni, au 200 Middlefield Road, Suite 104, Menlo Park, 94024 Californie, Etats-Unis d'Amérique;

- Le siège social d'Intertrust Management (Luxembourg) S.à r.l. a été transféré du 13-15, avenue de la Liberté, L-1931

Luxembourg, au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg;

- L'adresse professionnelle des gérants Richard BREKELMANS, Elizabeth TIMMER et Johan DEJANS a changé du 13-15,

avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 avril 2014.

Carsten SÖNS
<i>Mandataire

Référence de publication: 2014056057/25.
(140064645) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2014.

Real Marku Lux Estates Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1899 Kockelscheuer, 55, allée de la Poudrerie.

R.C.S. Luxembourg B 150.039.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Itzig, le 17 avril 2014.

<i>Pour RML S.A R.L.
FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN S.A R.L.

Référence de publication: 2014056163/12.
(140064140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2014.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

76512


Document Outline

ACRON Wien West A3 S.A.

Actavis Funding SCS

Actavis Funding SCS

Dolphimmo Investments S.A.

EIM Participations Luxembourg S.A.

FM Racing S.A.

France Properties Invest S.A.

Gamax Management AG

Genesta Nordic Capital Fund Management S.à r.l.

Genesta Property Nordic Luxembourg Sarl

G.O. IA - Luxembourg One S.à r.l.

Hosta

Hubis S.A.

IFS Capital Luxemburg II S.A.

Inolux S.A.

Inspiration Concept Lux S.à r.l.

Inspiration Concept Lux S.à r.l.

Iris Participations S.A.

IVG Praterstrasse Immobilien GmbH

Jardines Inmo S.A.

Jocan S.à r.l.

KLP Real Estate Queen Anne's Chambers S.à.r.l

Koma Services Corporation

KoMed Home Care S.A.

Lehwood Holdings S.à. r.l.

Lepus Holdings (Lux) S.à r.l.

Liberfy S.A.

Lilas Securities Sàrl

Lion/Gem Luxembourg 3 S.à r.l.

Logiparts S.A.

Logiparts S.A.

Lux-Impact S.à r.l.

Magellan Profit Invest S.A.

Minhal France S.à r.l.

Mobile Telesystems Finance S.A.

Moussepage S.à r.l.

Musca S.A.

Nascar Finance S.A.

N.M.A. Benelux

N.M.A. Benelux

N.M.A. Benelux S.A.

N.M.A. Benelux S.A.

Panda TMT Investments S.à r.l.

Petit Castelet S.à r.l.

PG Investments International S.A.

Property Trust Kali, S.à r.l.

P.S.M. Investment S.A.

Real Marku Lux Estates Sàrl

Santander SICAV

Sendosa S.à r.l.

Swedbank Robur International

Thorp S.à r.l.

T. Rowe Price Funds Sicav

WealthCap S.A. SICAV-SIF