This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1486
10 juin 2014
SOMMAIRE
3i Infrastructure (Luxembourg) Holdings
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71287
3i Infrastructure (Luxembourg) S. à r.l. . .
71288
AC Revocable Trust s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
71284
Airsim Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71285
A&K S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71286
Alphatax S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71284
Amarante SPF S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71288
Aperam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71283
AS-Dusty Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71283
ASSA ABLOY Branding S.à r.l. . . . . . . . . . .
71282
Auto Sport Diffusion S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
71282
Azeta SPF S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71282
Bievelez s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71282
Borletti Group Management S.A. . . . . . . . .
71288
Boulangerie-Pâtisserie Christian Schuma-
cher S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71288
By B.C. S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71283
Capula Luxembourg Limited . . . . . . . . . . . .
71318
Coparin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71284
CPI Asia Shinjuku II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
71284
Cruise Management S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
71292
CSN Resources S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71283
DD Constructions S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
71284
ESCF Laatzen S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71287
F&A Prom S.à .r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71324
FIP (Europe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71287
Gilmour Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
71315
Immowest Lux I S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
71327
International Partners and Associates S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71285
Marguerite Wind Butendiek S.à r.l. . . . . . .
71300
multisystems S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71286
Nadine SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71291
New Ypso Management Benetti S.C.A. . .
71290
NPF Soparfi D S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71290
NSK Euro Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
71290
OCM Luxembourg POF IV GLP Blocker
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71291
Olamobile S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71291
Olivia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71291
Orxeo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71290
Outlet Site Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
71289
Outlet Site JV S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71289
O-Wind S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71289
Oxalya Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71285
Oytis S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71289
Parc Avenue Capital S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
71291
Planeta Industries S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71288
secupay S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71286
Tata Consultancy Services Luxembourg
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71285
VDMC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71328
Vela Real Estate Credit Holdings I S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71328
VIII Chateau Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
71328
Waldimmo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71328
Zulia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71287
71281
L
U X E M B O U R G
Bievelez s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3313 Bergem, 95, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 173.785.
Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014050359/10.
(140057854) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2014.
Auto Sport Diffusion S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.
Siège social: L-1225 Luxembourg, 28, rue Beatrix de Bourbon.
R.C.S. Luxembourg B 68.845.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 07 avril 2014.
<i>Pour compte de Auto Sport Diffusion S.A.
i>Fiduplan S.A.
Référence de publication: 2014050326/12.
(140057453) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2014.
ASSA ABLOY Branding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 172.849.
Les statuts coordonnés au 03/04/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Redange-sur-Attert, le 08/04/2014.
Me Cosita Delvaux
<i>Notairei>
Référence de publication: 2014050319/12.
(140057800) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2014.
Azeta SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 165.996.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 28 mars 2014.i>
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide d'élire pour
la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2014 comme suit:
<i>Conseil d'administration:i>
MM. Andréa Carini, demeurant professionnellement 20 rue de la Poste, L-2346, Luxembourg, président;
Marco Gostoli, demeurant professionnellement 20 rue de la Poste, L-2346, Luxembourg, administrateur;
Mme Hélène Mercier, demeurant professionnellement 20 rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, administrateur.
<i>Commissaire aux comptes:i>
Finsev S.A., 5 Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
AZETA SPF S.A.
Société de Gestion de Patrimoine Familial
Signatures
Référence de publication: 2014050328/20.
(140057652) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2014.
71282
L
U X E M B O U R G
AS-Dusty Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3446 Dudelange, 20, rue Mathias Kungs.
R.C.S. Luxembourg B 115.042.
Le bilan approuvé au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 avril 2014.
Référence de publication: 2014050318/10.
(140057996) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2014.
By B.C. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2328 Luxembourg, 20, rue des Peupliers.
R.C.S. Luxembourg B 185.891.
Il résulte de la réunion du conseil de gérance de la Société en date du 25 février 2014 que le siège social de la société
a été transféré au 20, rue des Peupliers L-2328 Luxembourg, avec effet au 25 février 2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 7 avril 2014.
Référence de publication: 2014050350/12.
(140057459) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2014.
Aperam, Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12C, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 155.908.
Les comptes annuels statutaires au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014050316/10.
(140057467) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2014.
CSN Resources S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 63, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 148.403.
En date du 03 avril 2014, l'Actionnaire Unique de la Société a pris les décisions suivantes:
- Réélection de Martin Paul Galliver au poste d'Administrateur A de la Société, jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle
approuvant les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2014 et qui se tiendra en 2015;
- Réélection de Johannes Laurens de Zwart au poste d'Administrateur A, jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle
approuvant les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2014 et qui se tiendra en 2015;
- Réélection de Catalino Nunes Moniz Cabrai au poste d'Administrateur A, jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle
approuvant les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2014 et qui se tiendra en 2015;
- Réélection de Mario Henrique Melillo au poste d'Administrateur B, jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle approuvant
les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2014 et qui se tiendra en 2015;
- Réélection de Pricewaterhousecoopers Luxembourg au poste de réviseur d'entreprises agréé, jusqu'à l'Assemblée
Générale Annuelle approuvant les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2014 et qui se tiendra en 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
CSN Resources S.A.
Manacor (Luxembourg) S.A.
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2014050421/22.
(140058108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2014.
71283
L
U X E M B O U R G
Coparin S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 38.554.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 68447 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014050416/10.
(140058093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2014.
CPI Asia Shinjuku II S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 128.572.
<i>Extrait des résolutions des associés du 13 mars 2014i>
Les associés de la Société ont décidé comme suit:
- d'accepter !a démission d'IDS Lux S.à r.l. en tant que gérant de la Société avec effet au 1
er
avril 2014.
Luxembourg, le 08 avril 2014.
Christine Otting.
Référence de publication: 2014050418/12.
(140057531) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2014.
DD Constructions S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4710 Pétange, 56, rue d'Athus.
R.C.S. Luxembourg B 167.493.
Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014050432/9.
(140057417) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2014.
AC Revocable Trust s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 25.000,00.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 5, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 165.629.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 avril 2014.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2014050291/12.
(140057404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2014.
Alphatax S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6440 Echternach, 42, rue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 152.558.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2014050307/11.
(140057396) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2014.
71284
L
U X E M B O U R G
International Partners and Associates S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 44.303.
Par la présente, je vous informe que je dénonce le siège social de la société INTERNATIONAL PARTNERS AND
ASSOCIATES S.A., immatriculée au RCS de Luxembourg sous le numéro B44303 qui était préalablement domiciliée en
mon étude au 10, rue Willy Goergen à L-1636 Luxembourg.
La présente prend effet immédiatement.
Luxembourg, le 04/04/2014.
Me Lex THIELEN.
Référence de publication: 2014050255/11.
(140056853) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2014.
Tata Consultancy Services Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8308 Capellen, 89D, rue Pafebruch, Parc d'activités Capellen.
R.C.S. Luxembourg B 112.110.
Suite à une réunion du Conseil d'Administration en date du 17 décembre 2013
la démission de l'administrateur:
- Monsieur Per BRAGEE, administrateur
demeurant 3089 Strawinskylaan, NL-1077 ZX Amsterdam
est acceptée avec effet immédiat
est élu nouvel administrateur:
- Monsieur Amit Kapur,
demeurant Symphony Building - 20
th
Floor,
Gustav Mahlerplein 85-91, NL - 1082 MS Amsterdam
mandat qui prendra fin à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2014.
TATA CONSULTANCY SERVICES LUXEMBOURG S. A.
Signature
Référence de publication: 2014050259/19.
(140056789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2014.
Airsim Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.
R.C.S. Luxembourg B 172.404.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014050303/9.
(140057820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2014.
Oxalya Group S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 103.316.
EXTRAIT
La convention de domiciliation conclue entre la société Axiome Audit S.à.r.l. dont le siège social est situé au 10B rue
des Mérovingiens à L-8070 Bertrange et la société anonyme OXALYA GROUP S.A., inscrite au Registre de Commerce
de Luxembourg sous le numéro B 103316 en vertu de laquelle la société OXALYA GROUP S.A. avait fait élection de son
siège social à l'adresse susmentionnée a été dénoncée avec effet immédiat au 31 décembre 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bertrange, le 31 décembre 2013.
AXIOME AUDIT S.à.r.l.
Marco RIES
Référence de publication: 2014050716/15.
(140057429) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2014.
71285
L
U X E M B O U R G
secupay S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6755 Grevenmacher, 1, place du Marché.
R.C.S. Luxembourg B 159.416.
Bei Gelegenheit der außergewöhnlichen Generalversammlung vom 2. April 2014, wurden folgende Beschlüsse gefasst:
- Herr Reuter, Herr Fontanari und Frau Schroeder scheiden aus dem Verwaltungsrat aus, mit Wirkung zum 2. April
2014.
- Herr Hans-Peter Weber, wohnhaft in D-01099 Dresden, Bautzner Strasse 139, wird die Geschäfte als alleiniges
Verwaltungsratsmitglied gemäß Artikel 7 der Satzung führen. Herr Weber kann die Gesellschaft durch seine Einzelun-
terschrift rechtsgültig verpflichten.
- Die Mandate des Verwaltungsratsmitgliedes Herr Hans-Peter Weber und des Rechnungskommissars G.T. Fiduciaires
S.A. werden verlängert und enden bei Gelegenheit der Generalversammlung im Jahre 2018.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 8. April 2014.
G.T. Experts Comptables S.àr.l.
Luxembourg
Référence de publication: 2014050264/19.
(140057633) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2014.
multisystems S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 11A, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 110.249.
Le bilan au 31.12.2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 avril 2014.
Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L-1013 Luxembourg
Référence de publication: 2014050263/14.
(140057491) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2014.
A&K S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 300.000,00.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 39.766.
<i>Résolutions de Abercrombie & Kent Group Of Companies S.A., associée unique de A&K S.à.r.l. (la «Société») prises le 7 avril 2014i>
Il est pris acte de la démission de:
- Monsieur Jonathan ASHLEY, en date du 2 avril 2014; et
- Monsieur Gordon Knight SMITH, en date du 31 mars 2014.
tous deux, gérants WGT.
Il a été résolu de nommer, avec effet au 7 avril 2014, comme nouveaux gérants WGT:
a) M. Cameron MACDOUGALL, né le 24 août 1976 à Washington, Etats-Unis d'Amérique; et
b) M. Kevin KRIEGER, né le 28 mai 1969 en Californie, Etats-Unis d'Amérique,
tous deux, avec adresse professionnelle au 1345 Avenue of the Americas, New York, New York 10105, U.S.A.
La durée du mandat des deux nouveaux gérants WGT est illimitée.
<i>Pour et au nom de A&K S.A.R.L.
i>LG@VOCATS
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2014050266/21.
(140057462) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2014.
71286
L
U X E M B O U R G
3i Infrastructure (Luxembourg) Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue John F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 124.331.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 avril 2014.
Référence de publication: 2014050191/10.
(140057129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2014.
Zulia S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 34, rue Philippe II.
R.C.S. Luxembourg B 85.310.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014050188/9.
(140056643) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2014.
ESCF Laatzen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 171.930.
Il est porté à la connaissance de tiers que:
En date du 22 janvier 2014, la dénomination du gérant IREIM Services Luxembourg PSF S.à r.l. a été modifiée en celle
de IREIM Services Luxembourg S.à r.l.
Luxembourg, le 4 avril 2014.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2014050474/13.
(140057321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2014.
FIP (Europe), Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 159.177.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 21 mars 2014i>
Changement d'adresse d'Administrateurs
Le Conseil d'Administration acte le changement d'adresse des Administrateurs suivants:
La société INTERNATIONAL BUSINESS CONSULTANTS S.A. (Numéro d'immatriculation B 51863) est domiciliée
avec effet au 1
er
janvier 2014 au 3, Boulevard ROYAL à L-2449 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.
La société FIP (Luxembourg) S.A. (Numéro d'immatriculation B 79252) est domiciliée avec effet au 1
er
janvier 2014
au 3, Boulevard ROYAL à L-2449 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.
Changement d'adresse du délégué à la gestion journalière
Le Conseil d'Administration acte le changement d'adresse du délégué à la gestion journalière:
La société INTERNATIONAL BUSINESS CONSULTANTS S.A. (Numéro d'immatriculation B 51863), Administrateur
Délégué, est domiciliée avec effet au 1
er
janvier 2014 au 3, Boulevard ROYAL à L-2449 Luxembourg, Grand Duché de
Luxembourg.
INTERNATIONAL BUSINESS CONSULTANTS, S.A.
Représentée par M. Marc HURNER
<i>Administrateur-déléguéi>
Référence de publication: 2014050250/22.
(140056734) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2014.
71287
L
U X E M B O U R G
Amarante SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 33.893.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014050277/10.
(140058158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2014.
3i Infrastructure (Luxembourg) S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue John F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 124.469.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 avril 2014.
Référence de publication: 2014050193/10.
(140057128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2014.
Borletti Group Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 116.174.
Le bilan au 31/12/2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014050345/9.
(140057776) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2014.
Boulangerie-Pâtisserie Christian Schumacher S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7220 Walferdange, 61, route de Diekirch.
R.C.S. Luxembourg B 148.112.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014050347/9.
(140057377) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2014.
Planeta Industries S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 160.097.
Il résulte de la décision de l'associé unique de la Société du 17 mars 2014 que Monsieur Malte Hansen, né le 13 Octobre
1983 à Koblenz (Allemagne) et domicilié professionnellement au 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, a été nommé
administrateur en remplacement de Monsieur Sérgio Raposo avec effet au 17 mars 2014 et pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 avril 2014.
Planeta Industries S.A.
Représentée par Helene Müller Schwiering
<i>Membre du conseil d'administrationi>
Référence de publication: 2014050729/16.
(140057388) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2014.
71288
L
U X E M B O U R G
Outlet Site Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 178.117.
Statuts coordonnés, suite à l’assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de rési-
dence à Esch/Alzette, en date du 22 octobre 2013 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 22 novembre 2013.
Référence de publication: 2014050706/11.
(140057206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2014.
Outlet Site JV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 178.113.
Statuts coordonnés, suite à l’assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de rési-
dence à Esch/Alzette, en date du 22 octobre 2013 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 22 novembre 2013.
Référence de publication: 2014050707/11.
(140057180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2014.
Oytis S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 110.315.
EXTRAIT
Il résulte du procès verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 4 avril 2014 que les mandats suivants ont été re-
conduits:
- Monsieur Massimo LONGONI, conseiller économique, demeurant au 10, rue Mathieu Lambert Schrobilgen, L-2526
Luxembourg, à la fonction d'administrateur et Président du Conseil d'administration
- Madame Laurence BARDELLI, employée privée, demeurant professionnellement au 2628 Rives de Clausen L-2165
Luxembourg, à la fonction d'administrateur
- Madame Valérie WESQUY, employée privée, demeurant professionnellement au 19, boulevard Grande Duchesse
Charlotte L-1331 Luxembourg, à la fonction d'administrateur
Ser.Com S.à.r.l., immatriculée au Registre de Commerce de Luxembourg B117942, ayant son siège social 19, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte L-1331 Luxembourg est nommée à la fonction de commissaire aux comptes de son prédé-
cesseur dont le mandat n'a pas été renouvelé.
Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire qui si
tiendra en 2020.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2014050709/22.
(140057368) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2014.
O-Wind S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 179.229.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 avril 2014.
Référence de publication: 2014050704/10.
(140057488) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2014.
71289
L
U X E M B O U R G
NSK Euro Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 3-7, rue Schiller.
R.C.S. Luxembourg B 104.327.
Les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014050700/10.
(140057554) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2014.
New Ypso Management Benetti S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 137.176.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014050698/9.
(140057310) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2014.
NPF Soparfi D S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 120.086.
Il est porté à la connaissance de tiers que:
En date du 22 janvier 2014, la dénomination du gérant IREIM Services Luxembourg PSF S.à r.l. a été modifiée en celle
de IREIM Services Luxembourg S.à r.l.
Luxembourg, le 4 avril 2014.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2014050699/13.
(140057350) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2014.
Orxeo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.400.000,00.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 176.416.
Il résulte d'un acte sous seing privé du 18 décembre 2013 que «COMPAGNIE FINANCIERE XEO dite «COFIXEO»
SC», société civile de droit français, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 499
197 713, ayant son siège social au 7, avenue Stéphane Mallarmé à Paris (75017), France, a cédé 640 parts sociales de EUR
10.- chacune de la société ORXEO S.à r.l, société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 42, rue de la Vallée,
L-2661 Luxembourg, à Monsieur Alexandre CELIER, né le 29 juillet 1969 à Metz, France, demeurant au 19 avenue du Gui
B-1180 Uccle, Belgique.
Veuillez noter que l'adresse de l'associé «COMPAGNIE FINANCIERE XEO dite «COFIXEO» SC», est 7, avenue
Stéphane Mallarmé à Paris (75017), France et non 7, avenue Stéphanie Mallarmé à Paris (75017).
Luxembourg, le 08 avril 2014.
<i>Pour: ORXEO S.à r.l
i>Société à responsabilité limitée
Experta Luxembourg
Société anonyme
Aurélie Katola / Susana Goncalves Martins
Référence de publication: 2014050715/22.
(140058042) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2014.
71290
L
U X E M B O U R G
Olamobile S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 161.158.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 68417 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014050712/10.
(140057998) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2014.
OCM Luxembourg POF IV GLP Blocker S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 133.293.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 avril 2014.
Référence de publication: 2014050711/10.
(140057975) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2014.
Nadine SA, Société Anonyme.
Siège social: L-2430 Luxembourg, 18, rue Michel Rodange.
R.C.S. Luxembourg B 71.454.
Le bilan au 31.12.2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 avril 2014.
Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L - 1013 Luxembourg
Référence de publication: 2014050697/14.
(140057873) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2014.
Olivia S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R.C.S. Luxembourg B 86.209.
Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Référence de publication: 2014050714/10.
(140057946) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2014.
Parc Avenue Capital S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach.
R.C.S. Luxembourg B 65.667.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 avril 2014.
Référence de publication: 2014050717/10.
(140057489) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2014.
71291
L
U X E M B O U R G
Cruise Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 185.869.
STATUTES
In the year two thousand and fourteen, on the twenty-fifth day of the month of March.
Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Cruise Investment S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited liability company) incorporated under the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, having
a share capital of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500) and in the process of being registered with the
Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg,
represented by Mrs. Flora Verrecchia, lawyer, professionally residing in Luxembourg pursuant to a proxy which shall
be registered together with the present deed.
The appearing party, acting in the above stated capacity, has requested the undersigned notary to draw up the articles
of incorporation of a limited liability company Cruise Management S.à r.l. (société à responsabilité limitée) which is hereby
established as follows:
Art. 1. Denomination. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name “Cruise Management
S.à r.l.” (the “Company”) is hereby formed by the appearing party and all persons who will become shareholders the-
reafter. The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.
Art. 2. Object. The object of the Company shall be the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg
and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and
development of its portfolio.
The Company may also carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of real estate,
properties and real estate rights in Luxembourg and abroad as well as any participations in any real estate enterprise or
undertaking in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those participa-
tions and assets.
The Company may further give guarantees, grant security interests, grant loans or otherwise assist the companies in
which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may also acquire loans including at a discount, originate loans and lend funds under any form, advance
money or give credit on any terms including without limitation resulting from any borrowings of the Company or from
the issue of any equity or debt securities of any kind to any person or entity as it deems fit in relation to any real estate
enterprise or undertaking. The Company may enter into swaps, futures, forwards, derivatives, options, repurchase, stock
lending and similar transactions, and, without prejudice to the generality of the foregoing, employ any techniques and
instruments in connection with its real estate activities. The Company may also enter into any guarantees, contracts of
indemnities, security interests and any other equivalent agreements in order to receive the benefit of any guarantee and/
or security interest granted in the context of such real estate activities. The Company may undertake any roles necessary
in connection with such lending activity including, without limitation, the role of arranger, lead manager, facility agent,
security agent, documentation agent. The Company shall not undertake such real estate lending or real estate loan
acquisition activities in a way that would require it to be regulated pursuant to the Luxembourg act dated 5 April 1993
on the financial sector, as amended or any future act or regulation amending or replacing such act.
The Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or indirectly
in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purposes.
In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their admi-
nistration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other
advisors.
Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period.
Art. 4. Registered Office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an
extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles of
association.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the
case may be the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
71292
L
U X E M B O U R G
In the event that the manager, or as the case may be the board of managers, should determine that extraordinary
political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances;
such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified
to any interested parties by the manager or as the case may be the board of managers.
Art. 5. Share capital. The issued share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euros (EUR
12,500) represented by five hundred (500) shares with a nominal value of twenty-five Euros (EUR 25) each. The capital
of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for
amendment of these articles of association and the Company may proceed to the repurchase of its other shares upon
resolution of its shareholders.
Any available share premium shall be distributable.
Art. 6. Transfer of Shares. Shares are freely transferable among shareholders. Except if otherwise provided by law, the
share transfer to non-shareholders is subject to the consent of shareholders representing at least seventy-five per cent
(75%) of the Company's share capital.
Art. 7. Management of the Company. The Company is managed by one or several managers who do not need to be
shareholders.
The sole manager or as the case may be, the board of managers, is vested with the broadest powers to manage the
business of the Company and to authorise and/or perform all acts of disposal and administration falling within the purposes
of the Company. All powers not expressly reserved by the law or by the articles of association to the general meeting
shall be within the competence of the sole manager or as the case may be, the board of managers.
Vis-à-vis third parties the sole manager or as the case may be, the board of managers, has the most extensive powers
to act on behalf of the Company in all circumstances and to do, authorise and approve all acts and operations relative to
the Company and not reserved by law or these articles of association to the general meeting of shareholders.
The managers are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of share-
holders, which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed
for an undetermined period. The managers may be re-elected but their appointment may also be revoked with or without
cause (ad nutum) at any time.
In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. Any manager may participate in
any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the
persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also at
any time be held by conference call or similar means only. The participation in, or the holding of, a meeting by these
means is equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be
represented at meetings of the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager
may accept and vote.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours (24) at
least in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by cable, telegram, telex, e-mail or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening
notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted
by the board of managers.
Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company.
The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman of that meeting or, in its absence,
by any two managers. Copies or excerpts of such minutes shall be signed by the chairman of that meeting or by any two
managers.
The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means
when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety
will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including circular
resolutions, may be conclusively certified or an extract thereof may be issued under the individual signature of any
manager.
The Company will be bound by the sole signature in the case of a sole manager, and in the case of a board of managers
by the sole signature of anyone of the managers. In any event the Company will be validly bound by the sole signature of
any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by the sole manager (if there is only
one) or as the case may be the board of managers or anyone of the managers.
Art. 8. Liability of the Managers. The manager(s) are not held personally liable for the indebtedness of the Company.
As agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties.
71293
L
U X E M B O U R G
Subject to the exceptions and limitations listed below, every person who is, or has been, a manager or officer of the
Company shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against all
expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding which he becomes
involved as a party or otherwise by virtue of his being or having been such manager or officer and against amounts paid
or incurred by him in the settlement thereof. The words "claim", "action", "suit" or "proceeding" shall apply to all claims,
actions, suits or proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words "liability"
and "expenses" shall include without limitation attorneys' fees, costs, judgements, amounts paid in settlement and other
liabilities.
No indemnification shall be provided to any manager or officer:
(i) against any liability to the Company or its shareholders by reason of wilful misfeasance, bad faith, gross negligence
or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office;
(ii) with respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated to have acted in bad faith and not in
the interest of the Company; or
(iii) in the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of competent jurisdiction or by
the board of managers.
The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any manager
or officer may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such manager or officer
and shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein shall
affect any rights to indemnification to which corporate personnel, including directors and officers, may be entitled by
contract or otherwise under law.
Expenses in connection with the preparation and representation of a defence of any claim, action, suit or proceeding
of the character described in this article shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof upon receipt
of any undertaking by or on behalf of the officer or director, to repay such amount if it is ultimately determined that he
is not entitled to indemnification under this article.
Art. 9. Shareholder voting rights. Each shareholder may take part in collective decisions. He has a number of votes
equal to the number of shares he owns and may validly act at any meeting of shareholders through a special proxy.
Art. 10. Shareholder meetings. Decisions by shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as pre-
scribed by Luxembourg Company law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings. Any regularly constituted
meeting of shareholders of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the entire
body of shareholders of the Company.
Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to shareholders to their address appearing
in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire
share capital of the Company is represented at a meeting, the meeting may be held without prior notice.
In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the shareholders at their addresses
inscribed in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days before the proposed effective date
of the resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for
collective decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous
written resolution may be passed at any time without prior notice.
Except as otherwise provided for by law, (i) decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by
shareholders representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting or
first written resolution, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions
shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented. (ii) However, decisions
concerning the amendment of the articles of association are taken by (x) a majority of the shareholders (y) representing
at least three quarters of the issued share capital and (iii) decisions to change of nationality of the Company are to be
taken by Shareholders representing one hundred percent (100%) of the issued share capital.
At no time shall the Company have more than thirty (30) shareholders. At no time shall an individual be allowed to
become a shareholder of the Company.
Art. 11. Accounting Year. The accounting year begins on 1
st
January of each year and ends on 31
st
December of the
same year save for the first accounting year which shall commence on the day of incorporation and end on 31
st
December
2014.
Art. 12. Financial Statements. Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the
manager or, as the case may be, the board of managers.
The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.
Art. 13. Distributions. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction
ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.
The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the manager,
or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood
71294
L
U X E M B O U R G
that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by
profits carried forward and distributable reserves and premium but decreased by losses carried forward and sums to be
allocated to a reserve to be established by law.
The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal
reserve account.
Art. 14. Dissolution. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators
who may be but do not need to be shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders who will
specify their powers and remunerations.
Art. 15. Sole Shareholder. If, and as long as one shareholder holds all the shares of the Company, the Company shall
exist as a single shareholder company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10
th
August 1915 on commercial com-
panies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.
Art. 16. Applicable law. For anything not dealt with in the present articles of association, the shareholders refer to the
relevant legislation.
<i>Subscription and paymenti>
The articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the appearing party has
subscribed and entirely paid-up the following shares:
Subscriber
Number
of shares
Subscription
price (EUR)
Cruise Investment S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 EUR 12,500
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 EUR 12,500
Evidence of the payment of the total subscription price has been shown to the undersigned notary.
<i>Expenses, Valuationi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately EUR 1,500.-.
<i>Extraordinary general meetingi>
The sole shareholder has forthwith taken immediately the following resolutions:
1. The registered office of the Company is fixed at: 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
2. The following person is appointed manager of the Company for an undetermined period of time subject to the
articles of association of the Company with such signature powers as set forth in the articles of association of the Company:
- BRE/Management 7 S.A., a société anonyme incorporated under the laws of Luxembourg, with registered office at
2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg and being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in
Luxembourg under number B 180.304,
Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day before mentioned.
The document having been read to the appearing party, who requested that the deed should be documented in English,
the said appearing party signed the present original deed together with the notary, having personal knowledge of the
English language. The present deed, worded in English, is followed by a translation into German. In case of divergences
between the English and the German text, the English version will prevail.
The document having been read to the appearing party, known to the notary by its name, first name, civil status and
residence, the said appearing party signed together with the notary the present deed.
Folgt die Deutsche Übersetzung des Vorstehenden Textes:
Im Jahre zweitausendvierzehn, am fünfundzwanzigsten März.
Vor dem unterzeichnenden Notar Maître Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
Ist erschienen,
Cruise Investment S.à r.l., eine société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) luxemburgi-
schen Rechts mit Sitz in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, deren Gesellschaftskapital zwölftausendfünfhundert
Euro (EUR 12.500) beträgt, und die dabei ist im Registre de Commerce et des Sociétés in Luxemburg eingetragen zu
werden,
hier vertreten durch Frau Flora Verrecchia, Rechtsanwältin, beruflich wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer privat-
schriftlichen Vollmacht welche vorliegender Urkunde beigefügt ist um mit dieser bei der Registrierungsbehörde einge-
reicht zu werden.
71295
L
U X E M B O U R G
Die erschienene Partei hat in ihrer vorgenannten Eigenschaft den unterzeichnenden Notar ersucht, die Gründungs-
satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) "Cruise Management S.à r.l." wie
folgt zu beurkunden.
Art. 1. Gesellschaftsname. Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen
"Cruise Management S.à r.l." (die "Gesellschaft") wird hiermit von der erschienenen Partei und allen Personen, die gege-
benenfalls zukünftig als Gesellschafter eintreten, gegründet. Die Gesellschaft wird durch vorliegende Satzung und durch
die entsprechende luxemburgische Gesetzgebung geregelt.
Art. 2. Gesellschaftszweck. Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen in jeder beliebigen Form an in-
und ausländischen Gesellschaften sowie jede andere Form von Investitionen, sowie den Erwerb durch Kauf, Zeichnung
oder andere Art und Weise wie Übertragung durch Verkauf oder Tausch von Finanzinstrumenten jeder Art und die
Verwaltung, Aufsicht und Entwicklung ihres Portfolios.
Die Gesellschaft kann ebenfalls alle Transaktionen welche sich auf direkten oder indirekten Erwerb von Grundbesitz,
Eigentum, und Grundbesitzrechte in Luxemburg oder im Ausland oder auf den Erwerb von Beteiligungen an Unternehmen
welche im Besitz von Grundrechten sind oder von Unternehmensbeteiligungen jedweder Form beziehen, durchführen
sowie die Verwaltung, Aufsicht und Entwicklung dieser Beteiligungen und dieses Vermögen ausführen.
Die Gesellschaft kann Bürgschaften geben, Sicherheiten leisten, Darlehen ausgeben oder die Gesellschaften an denen
die Gesellschaft direkte oder indirekte Beteiligungen besitzt oder die zur Gruppe von Gesellschaften gehört, der die
Gesellschaft angehört, in jeder anderen Form unterstützen.
Die Gesellschaft kann außerdem in jeder beliebigen Form Darlehen erwerben, auch mit Preisnachlass, Darlehen ver-
geben, Kapital verleihen, sowie Vorschüsse gewährleisten oder unter jeglichen Konditionen Kredite vergeben, einschließ-
lich und ohne Einschränkungen derer Kredite, in Bezug auf ein Immobilien-Unternehmen oder -Unterfangen, die sich von
jeglichen Kreditaufnahmen der Gesellschaft oder von der Ausgabe von Kapital oder Schuldtitel jeglicher Art an alle Per-
sonen und Unternehmen, für die es für richtig empfunden wurde, ergeben. Die Gesellschaft kann Swaps, Futures,
Forwards, derivative Instrumente, Optionen, Rückkäufe, Wertpapierverleihe und ähnliche Transaktionen abschließen und
unbeschadet der Allgemeingültigkeit des Vorstehenden, jegliche Methode und Instrumente im Zusammenhang mit ihren
Immobiliengeschäften einsetzen. Die Gesellschaft kann auch jegliche Verträge über Garantien, Entschädigungen, Sicher-
heiten und alle weiteren äquivalente Verträge abschließen, so dass der Nutzen der, im Rahmen solcher Immobilienge-
schäfte vergebenen, Garantien und/oder Sicherheiten ihr zu Gute kommen kann. Die Gesellschaft kann im Rahmen solcher
Immobiliengeschäfte jegliche erforderliche Rolle übernehmen, einschließlich und ohne Einschränkungen der Rolle des
Arranger, lead Manager, Facility Agent, Security Agent, Documentation Agent. Die Gesellschaft wird die Tätigkeit der
Immobilienfinanzierung oder des Immobilienkrediterwerbs nicht in einer Weise ausüben, die eine Regulierung erfordern
würde gemäß der geänderten Fassung des Gesetzes des 5. Aprils 1993 bezüglich des Finanzsektors oder jeglichen zu-
künftigen Gesetzes oder Regulierungsmaßnahme, die dieses Gesetz abändern oder ersetzen sollte.
Die Gesellschaft kann alle geschäftlichen, technischen, finanziellen ebenso wie alle andere direkt oder indirekt ver-
bundenen Tätigkeiten welche die Erfüllung des Geschäftszwecks in den oben genannten Bereichen erleichtern, vorneh-
men.
Unter anderem wird die Gesellschaft allen Gesellschaften ihres Portfolios die für die Verwaltung, Entwicklung und
Aufsicht dieser Gesellschaften notwendigen Leistungen zur Verfügung stellen. Für diesen Zweck kann die Gesellschaft die
Unterstützung anderer Berater beanspruchen und auf solche zurückgreifen.
Art. 3. Geschäftsdauer. Die Gesellschaft ist auf unbegrenzte Dauer gegründet
Art. 4. Gesellschaftssitz. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg. Dieser kann,
durch Beschluss einer außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter die sich, in der für die Abänderung der
Satzung vorgesehenen Art und Weise beraten, an jeden Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.
Der eingetragene Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss des Geschäftsführers, beziehungsweise durch die Ge-
schäftsführung innerhalb der Gemeinde verlegt werden.
Die Gesellschaft kann Geschäfts- und Zweigstellen in Luxemburg und im Ausland errichten.
Sollte der Geschäftsführer, oder im Falle einer Geschäftsführung die Geschäftsführung, feststellen, dass außerordent-
liche politische, wirtschaftliche oder soziale Ereignisse eingetreten sind oder unmittelbar bevorstehen welche die
normalen Tätigkeiten der Gesellschaft an ihrem eingetragenen Sitz oder die problemlose Kommunikation zwischen die-
sem Sitz und Personen im Ausland beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zum
vollständigen Ende solcher ungewöhnlichen Umstände ins Ausland verlegt werden; derartige vorläufige Maßnahmen haben
keine Auswirkung auf die staatliche Zugehörigkeit der Gesellschaft, die unbeschadet einer solchen vorübergehenden
Sitzverlegung eine luxemburgische Gesellschaft bleibt. Solche vorübergehenden Maßnahmen werden vom Geschäftsführer
oder, im Falle einer Geschäftsführung, von der Geschäftsführung vorgenommen und jeglichen betroffenen Personen mit-
geteilt.
Art. 5. Gesellschaftskapital. Das ausgegebene Gesellschaftskapital der Gesellschaft beläuft sich auf zwölftausendfünf-
hundert Euro (EUR 12.500), eingeteilt in fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je fünfund-
zwanzig Euro (EUR 25).
71296
L
U X E M B O U R G
Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter in der für die Abänderung der
Satzung vorgesehenen Art und Weise erhöht oder verringert werden und die Gesellschaft kann seine anderen Gesell-
schaftsanteile durch Beschluss der Gesellschafter zurückkaufen.
Verfügbare Anteilsprämien können verteilt werden.
Art. 6. Übertragung der Anteile. Die Anteile sind unter den Gesellschaftern frei übertragbar. Soweit es das Gesetz
nicht anders bestimmt, bedarf die Übertragung von Anteilen auf Dritte der Einwilligung von Gesellschaftern, welche
zusammen mindestens fünfundsiebzig Prozent (75%) des Gesellschaftskapitals halten.
Art. 7. Geschäftsführung. Die Geschäftsführung der Gesellschaft erfolgt durch einen oder mehrere Geschäftsführer
die keine Gesellschafter sein müssen.
Der alleinige Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung ist mit den weitestreichenden Befugnissen aus-
gestattet, das Geschäft der Gesellschaft zu verwalten und ist dazu befugt, jede Handlungen und Tätigkeiten, die mit dem
Gegenstand der Gesellschaft im Einklang stehen, zu genehmigen und/oder auszuführen. Sämtliche Befugnisse, die nicht
ausdrücklich per Gesetz oder durch die vorliegende Satzung den Gesellschaftern vorbehalten sind, fallen in den Zustän-
digkeitsbereich des Geschäftsführers beziehungsweise der Geschäftsführung.
Gegenüber Dritten hat der Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung die weitestreichenden Befugnisse
um in allen Umständen, im Namen und Auftrag der Gesellschaft zu handeln und in jeden Umständen, jeden Akt und jede
Handlung, welche nicht durch die vorliegende Satzung oder durch die entsprechende luxemburgische Gesetzgebung im
Kompetenzbereich der Gesellschafterversammlung liegt, im Auftrag der Gesellschaft vorzunehmen, zu erlauben und gut-
zuheißen.
Die Geschäftsführer werden durch mehrheitlichen Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter gewählt und
abberufen, welche ihre Befugnisse und die Amtsdauer beschließt. Wenn keine Frist gesetzt wird, dann sind die Geschäfts-
führer auf unbestimmte Zeit ernannt. Die Geschäftsführer können wiedergewählt werden, jedoch kann ihre Ernennung
zu jeder Zeit mit oder ohne Grund (ad nutum) widerrufen werden.
Im Falle mehrerer Geschäftsführer bilden diese die Geschäftsführung. Jeder Geschäftsführer kann an jeder Sitzung der
Geschäftsführung teilnehmen mittels Telefonkonferenz oder anderen zur Verfügung stehenden Kommunikationsmitteln
insofern gewährleistet ist, dass alle an der Sitzung teilnehmenden Personen sich hören und miteinander kommunizieren
können. Eine Sitzung kann jederzeit mittels einer Telefonkonferenz oder ähnlichen Kommunikationsmitteln abgehalten
werden. Die Teilnahme oder das Abhalten einer Sitzung mit Hilfe dieser Mittel entspricht einer persönlichen Teilnahme
an der betroffenen Sitzung. Die Geschäftsführer können sich in den Sitzungen ohne Einschränkung der Anzahl der Voll-
machten durch einen anderen Geschäftsführer, der hierzu bevollmächtigt ist, vertreten lassen.
Die Geschäftsführer sind mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor Beginn einer Sitzung der Geschäftsführung
mittels schriftlicher Einberufung, zu benachrichtigen, außer in Notfällen, in welchem Fall die Art und die Gründe dieser
Umstände in der Einberufung erläutert werden müssen. Auf das Recht auf die oben beschriebene Weise einberufen zu
werden kann jeder Geschäftsführer durch schriftliche Zustimmung per Telegramm, Telekopie, Email, Telefax oder per
ähnlichem Kommunikationsmittel verzichten. Spezifische Einberufungen sind nicht notwendig für Sitzungen, welche vorher
zu einem durch Geschäftsführungsbeschluss genehmigten Zeitplan und zu vorgesehenen Zeiten und an vorbestimmten
Orten abgehalten werden.
Entscheidungen der Geschäftsführung werden durch die Mehrheit der Geschäftsführer der Gesellschaft gefasst.
Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden der Sitzung oder, in seiner Abwesenheit,
von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Protokolle werden vom Vorsitzenden oder von
zwei Geschäftsführern unterzeichnet.
Schriftliche Beschlüsse der Geschäftsführung können, aus einem einzigen oder mehreren einzelnen Dokumenten, gültig
abgeschlossen werden, wenn sie von allen Mitgliedern der Geschäftsführung schriftlich, per Telegramm, Telefax oder per
ähnlichem Kommunikationsmittel genehmigt wurden. Die verschiedenen Dokumente gleichen Inhalts bilden zusammen
einen gültigen schriftlichen Beschluss. Beschlüsse der Geschäftsführung, einschließlich schriftliche Beschlüsse, können von
einem einzelnen Geschäftsführer beweiskräftig beglaubigt und ein Auszug davon beweiskräftig unterschrieben werden.
Die Gesellschaft wird durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers und durch die Unterschrift eines einzelnen
Geschäftsführers im Falle einer Geschäftsführung gebunden. Die Gesellschaft ist in jedem Fall wirksam durch die Unter-
schrift einer oder mehrerer hierzu durch den alleinigen Geschäftsführer, beziehungsweise durch die Geschäftsführung
oder einer der Geschäftsführer, bevollmächtigten Personen, gebunden.
Art. 8. Haftung der Geschäftsführung. Die Geschäftsführer sind für Verschuldung der Gesellschaft nicht persönlich
haftbar. Als Vertreter der Gesellschaft sind sie jedoch für die Ausführung ihrer Aufgaben und Pflichten verantwortlich.
Vorbehaltlich den unten aufgeführten Ausnahmen und Beschränkungen, wird jede Person, die ein Geschäftsführer oder
leitender Angestellter der Gesellschaft ist oder war, von der Gesellschaft in vollem, gesetzlich erlaubten, Umfang gegen
Verbindlichkeiten und gegen alle Ausgaben, welche üblicherweise entstanden sind oder von ihm gezahlt wurden in Ver-
bindung mit Klagen, Prozessen oder Verfahren in die er als Partei oder anderweitig eintritt aufgrund dessen, dass er ein
Geschäftsführer oder leitender Angestellter ist oder gewesen ist und die diesbezüglich gezahlten Beträge oder von durch
deren Beilegung entstandenen Beträge, schadlos gehalten werden. Die Begriffe „Klage“, „Streitsache“, „Prozess“ oder
71297
L
U X E M B O U R G
„Verfahren“ finden auf alle anhängigen oder bevorstehenden Klagen, Streitsachen, Prozesse oder Verfahren Anwendung
(zivilrechtlich, strafrechtlich oder sonstige, einschließlich Rechtsmittel) Anwendung und die Begriffe „Verbindlichkeit“ und
„Ausgaben“ beinhalten ohne Beschränkung Anwaltskosten, Prozesskosten, Sicherheitsleistungen, gezahlte Beträge bei
Streitbeilegung und andere Verbindlichkeiten.
Einem Geschäftsführer oder leitendem Angestellten wird keine Schadloshaltung gewährt:
(i) gegen Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschaft oder ihrer Gesellschafter, aufgrund von vorsätzlich begangenen
unerlaubten Handlungen, Bösgläubigkeit, grober Fahrlässigkeit oder rücksichtsloser Missachtung der Aufgaben, die in
seiner Amtsführung enthalten sind;
(ii) im Zusammenhang mit jeglichen Verfahren bei welchen er wegen bösgläubigem und nicht im Interesse der Gesell-
schaft erfolgtem Handeln, verurteilt wurde; oder
(iii) im Falle einer Beilegung, es sei denn die Beilegung ist von einem Gericht unter zuständiger Gerichtsbarkeit oder
von der Geschäftsführung genehmigt worden.
Das Recht der Schadloshaltung, das hier vorgesehen ist, ist abtrennbar und berührt keine anderen Rechte auf die das
Verwaltungsratsmitglied oder der leitende Angestellte jetzt oder später ein Anrecht hat, und soll fortgeführt werden in
der Person, die aufgehört hat, ein Geschäftsführer oder leitender Angestellter zu sein und soll dem Vorteil der Erben,
Testamentsvollstreckern und Verwaltern einer solchen Person dienen. Nichts hierin Enthaltenes berührt die Rechte zur
Schadloshaltung, auf die Gesellschaftspersonal, eingeschlossen Geschäftsführer und leitende Angestellte, aufgrund von
Vertrag oder anderweitig durch Gesetz, Anspruch haben könnten.
Ausgaben in Verbindung mit Vorbereitung und Vertretung der Verteidigung einer Klage, Streitsache, Prozess oder
Verfahren beschrieben in diesem Artikel, soll von der Gesellschaft vor der endgültigen Verfügung darüber bei Zugang
jeglicher Unternehmung seitens oder im Namen eines leitenden Angestellten oder Geschäftsführers vorgestreckt werden,
um den benannten Betrag zurückzuzahlen wenn es letztlich bestimmt ist, dass er keinen Anspruch auf Schadloshaltung
unter diesem Artikel hat.
Art. 9. Stimmrechte der Gesellschafter. Jeder Gesellschafter kann an kollektiven Entscheidungen teilnehmen. Die Zahl
seiner Stimmen entspricht der Zahl seiner Gesellschaftsanteile und der Gesellschafter kann bei jeder Versammlung durch
eine spezielle Vollmacht vertreten werden.
Art. 10. Gesellschafterversammlungen. Die Beschlüsse der Gesellschafter werden in der im luxemburgischen Gesell-
schaftsrecht vorgeschriebenen Form und mit der darin vorgesehenen Mehrheit, schriftlich (soweit dies gesetzlich möglich
ist) oder in Gesellschafterversammlungen, gefasst. Jede ordnungsgemäß konstituierte Gesellschafterversammlung der
Gesellschaft beziehungsweise jeder ordnungsgemäß schriftlicher Beschluss vertritt die Gesamtheit der Gesellschafter der
Gesellschaft.
Die Einberufung der Versammlungen durch den Geschäftsführer/die Geschäftsführung hat mindestens acht (8) Tage
vor der Versammlung mittels eingeschriebenen Briefes an die Gesellschafter an ihre im Anteilsregister der Gesellschaft
eingetragene Adresse, zu erfolgen. Wenn das gesamte Gesellschaftskapital der Gesellschaft vertreten ist, kann die Sitzung
ohne vorherige Einberufung abgehalten werden.
Werden Beschlüsse im Wege eines Zirkularbeschlusses der Gesellschafter gefasst, so wird der Inhalt des Beschlusses
mindestens acht (8) Tage bevor der Beschluss wirksam werden soll, an alle Gesellschafter an ihre im Anteilsregister
eingeschriebene Adresse mittels eingeschriebenen Briefs übersandt. Die Beschlüsse werden wirksam bei Zustimmung
der vom Gesetz vorgesehenen Mehrheiten für gemeinsame Entscheidungen (oder, unter der Voraussetzung der Befrie-
digung der Mehrheitsvoraussetzungen, am in dieser Entscheidung festgelegten Tag). Einstimmige Zirkularbeschlüsse
können jederzeit ohne vorherige Ankündigung getroffen werden.
Soweit gesetzlich nichts anderes vorgesehen ist, (i) werden die in den Gesellschafterversammlungen zu fassenden
Beschlüsse von den Gesellschaftern getroffen, welche mehr als die Hälfte des Geschäftskapitals vertreten. Wird eine
solche Mehrheit bei der ersten Gesellschafterversammlung nicht erreicht, werden die Gesellschafter per Einschreiben zu
einer zweiten Gesellschafterversammlung geladen und die Beschlüsse werden sodann aufgrund der Mehrheit der abge-
gebenen Stimmen gefasst, unbeschadet der Anzahl der vertretenen Geschäftsanteile. (ii) Die Satzung kann jedoch nur mit
Zustimmung (x) der Mehrheit der Gesellschafter, welche (y) zwei Drittel des Gesellschaftskapitals vertreten, abgeändert
werden und (iii) Entscheidungen, die Nationalität der Gesellschaft zu ändern, bedürfen der Zustimmung von Gesellschaf-
tern, die einhundert Prozent (100%) des Gesellschaftskapitals vertreten.
Zu keiner Zeit soll die Gesellschaft mehr als dreißig (30) Gesellschafter haben. Zu keiner Zeit soll es einer natürlichen
Person gestattet sein, ein Gesellschafter der Gesellschaft zu werden.
Art. 11. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten (1.) Januar und endet am einunddreißigsten (31.) Dezember
eines jeden Jahres. Das erste Geschäftsjahr, welches am Tage der Gründung der Gesellschaft beginnt, wird am 31. De-
zember 2014 enden.
Art. 12. Jahresabschluss. Der alleinige Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung erstellt jedes Jahr die
Jahresabrechnung der Gesellschaft.
Jeder Gesellschafter kann die Jahresabrechnung am Sitz der Gesellschaft einsehen.
71298
L
U X E M B O U R G
Art. 13. Gewinnverwendung. Fünf Prozent (5%) des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft werden der gesetzlich
vorgeschriebenen Rücklage zugeführt. Diese Rücklageeinzahlungspflicht besteht nicht mehr, sobald die gesetzliche Rück-
lage zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.
Die Gesellschafter können auf der Grundlage eines von dem alleinigen Geschäftsführer, beziehungsweise der Ge-
schäftsführung angefertigten Zwischenabschlusses die Ausschüttung von Abschlagsdividenden beschließen, sofern dieser
Zwischenabschluss zeigt, dass ausreichend Gewinne und andere Reserven zur Ausschüttung zur Verfügung stehen, wobei
der auszuschüttende Betrag die seit dem Ende des vorhergehenden Geschäftsjahres erzielten Gewinne, für welches die
Jahresabschlüsse bereits bewilligt wurden, erhöht um die vorgetragenen Gewinne und ausschüttbaren Rücklagen, ver-
mindert um die vorgetragenen Verluste und die der gesetzlichen Rücklage zuzuführenden Beträge, nicht übersteigen darf.
Der Saldo kann nach Entscheidung der Gesellschafterversammlung an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.
Das Anteilsprämienkonto kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung an die Gesellschafter ausgeschüttet
werden. Die Gesellschafterversammlung kann beschließen, jeden Betrag vom Anteilsprämienkonto auf die gesetzliche
Rücklage zu übertragen.
Art. 14. Auflösung. Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft ernennen die Gesellschafter einen oder mehrere Liqui-
datoren, bei welchen es sich nicht um Gesellschafter handeln muss, zwecks der Durchführung der Auflösung und
bestimmen ihre Befugnisse und Vergütung.
Art. 15. Alleingesellschafter. Sofern nur ein Gesellschafter alle Geschäftsanteile der Gesellschaft hält, gilt Artikel 179
(2) des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften und die Artikel 200-1 und 200-2 finden u.a. Anwendung.
Art. 16. Anwendbares Recht. Sämtliche nicht ausdrücklich durch diese Satzung geregelten Angelegenheiten richten
sich nach den entsprechenden Regelungen des anwendbaren Gesetzes.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Nach dem die erschienene Partei die Gründungssatzung erstellt hat, hat sie das gesamte Gesellschaftskapital wie folgt
eingezahlt und gezeichnet:
Einzahler
Zahl der
Geschäftsanteile
Einzahlungspreis
(EUR)
Cruise Investment S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
EUR 12.500
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
EUR 12.500
Ein Beleg für die vollständige Einzahlung der Geschäftsanteile wurde dem unterzeichneten Notar vorgelegt.
<i>Kosteni>
Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund der vorlie-
genden Gesellschaftsgründung entstehen, werden auf ungefähr EUR 1.500,- geschätzt.
<i>Außerordentliche Beschlüsse des Gesellschaftersi>
Unverzüglich nach der Gründung der Gesellschaft hat der Alleinige Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:
1. Sitz der Gesellschaft ist in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg.
2. Die folgende Person wird für einen unbeschränkten Zeitraum zum Geschäftsführer der Gesellschaft mit der in der
Satzung der Gesellschaft beschriebenen Unterschriftsbefugnis ernannt:
- BRE/Management 7 S.A., eine Aktiengesellschaft (société anonyme) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 2-4, rue
Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg und eingetragen im Registre de Commerce et des Sociétés in Luxemburg unter der
Nummer B 180.304.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnende Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass auf Ersuchen der oben erschie-
nenen Partei, die vorliegende Urkunde in English abgefasst wird, gefolgt von einer deutschen Übersetzung.
Auf Ersuchen derselben erschienenen Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deut-
schen Text, ist die englische Fassung maßgebend.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die erschienene Partei die dem amtierenden Notar nach
Namen, Vornamen, Zivilstand und Wohnort bekannt, hat dieselbe zusammen mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.
Gezeichnet: F. VERRECCHIA und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 mars 2014. Relation: LAC/2014/14276. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - der Gesellschaft auf Begehr erteilt.
71299
L
U X E M B O U R G
Luxemburg, den 4. April 2014.
Référence de publication: 2014049670/450.
(140056614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2014.
Marguerite Wind Butendiek S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 37.500,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 1-3, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 172.706.
In the year two thousand and thirteen, on the fifth day of December,
before us, Maître Francis Kesseler, notary, residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,
there appeared:
(1) MARGUERITE HOLDINGS S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, with a
share capital of twenty-five thousand euros (EUR 25,000.-) and registered office at 1-3, boulevard de la Foire, L-1528
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies
under number B 162622 (“Marguerite”); and
(2) CDC Infrastructure, a société anonyme governed by the laws of France, with registered office at 56, rue de Lille,
F-75007 Paris, with registered number 450 055 090 (“CDC Infra”).
Marguerite is hereby represented by David S. HARRISON and Michael DEDIEU, acting as directors.
CDC Infra is hereby represented by Patrick Vandevoorde, Chief Executive Officer (Directeur Général).
The above appearing parties being collectively referred to as the “Shareholders”.
The Shareholders have requested the undersigned notary to document that the Shareholders are all the shareholders
of Marguerite Wind Butendiek S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, having a
share capital of thirty-seven thousand five hundred euro (EUR 37,500.-) with registered office at 1-3, boulevard de la
Foire, L-1528 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce
and Companies under number B 172706 (the "Company"), incorporated following a deed of the undersigned notary, of
8 November 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 11 December 2012, number
2996. The articles of association of the Company have for the last time been amended pursuant to a deed of the under-
signed notary of 29 November 2013, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
The Shareholders, represented as above mentioned, having recognised to be duly and fully informed of the resolutions
to be taken on the basis of the following agenda:
<i>Agendai>
1. To fully restate the articles of association of the Company without amending the corporate object of the Company,
for the purpose of, among others, converting ordinary shares in class A ordinary shares and class B ordinary shares,
setting the rights and obligations attached to the shares, deleting the authorised share capital, qualifying the directors as
class A and class B directors, amending the provisions related to the representation of the Company, introducing the
concept of “Reserved Matters”, appointing an auditor and setting out the governance rules of the Company.
2. To re-qualify (i) the twenty-five thousand (25,000) ordinary shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each
held by Marguerite Holdings S.à r.l. into twenty-five thousand (25,000) class A ordinary shares with a nominal value of
one euro (EUR 1.-) each and (ii) the twelve thousand five hundred (12,500) ordinary shares with a nominal value of one
euro (EUR 1.-) each held by CDC Infrastructure into twelve thousand five hundred (12,500) class B ordinary shares with
a nominal value of one euro (EUR 1.-) each.
3. To accept the resignations of Nicolas Merigo, director (gérant), and Michael Dedieu, director (gérant).
4. To set the number of directors (gérants) at three (3), comprised of two (2) class A directors (gérants) and one (1)
class B director (gérant).
5. To redesignate the existing directors (gérants) as class A directors (gérants) for an unlimited duration.
6. To appoint Julien Gailleton as class B director (gérant) for an unlimited duration.
7. To set the number of auditors at one (1) and to appoint Artemis as auditor of the Company for a period ending at
the annual general meeting of shareholders approving the annual accounts of the financial year ending on 31 December
2014.
8. Miscellaneous.
The Shareholders passed the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Shareholders resolved to fully restate the articles of association of the Company without amending the corporate
object of the Company, for the purpose of, among others, converting ordinary shares in class A ordinary shares and class
B ordinary shares, setting the rights and obligations attached to the shares, deleting the authorised share capital, qualifying
71300
L
U X E M B O U R G
the directors as class A and class B directors, amending the provisions related to the representation of the Company,
introducing the concept of “Reserved Matters”, appointing an auditor and setting out the governance rules of the Com-
pany.
The articles of association of the Company will from now on read as follows:
”Chapter I. - Form, Name, Registered office, Object, Duration
1. Form - Corporate Name.
1.1 There hereby exists a société à responsabilité limitée (the “Company”) governed by the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg (the “Laws”) and by the present articles of association (the “Articles”).
1.2 The Company may be composed of one single shareholder, owner of all the shares, or several shareholders, but
not exceeding forty (40) shareholders.
1.3 The Company exists under the name of “Marguerite Wind Butendiek S.à r.l.”.
2. Registered Office.
2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg.
2.2 It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an
extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
2.3 However, the Board of Directors of the Company is authorised to transfer the registered office of the Company
within the City of Luxembourg.
2.4 Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would
prevent the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be tem-
porarily transferred abroad until such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have
any effect on this Company's nationality, which, notwithstanding this temporary transfer of the registered office, will
remain a Luxembourg company. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the Board
of Directors.
3. Object.
3.1 The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign
companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or
otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other equity or debt instruments (convertible or not) of any kind
(including but not limited to synthetic securities), and the ownership, administration, development and management of
its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.
3.2 The Company may borrow in any form and proceed to the issue of bonds, debentures as well as any other type
of equity or debt instruments (convertible or not).
3.3 In a general fashion it may grant, directly or indirectly, assistance to affiliated or group companies (including but
not limited to the granting of any type of loan), take any controlling and/or supervisory measures and carry out any
operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.
3.4 In particular the Company may enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal
covenant or by mortgage or charge upon all or part of the property assets (present or future) of the undertaking or by
all or any of such methods, for the performance of any contracts or obligations of the Company and of any of its affiliated
or group companies, or any director, manager or other agent of the Company or any of its affiliated or group companies,
within the limits of any applicable law provision.
3.5 The Company may enter into any kind of credit derivative agreements, including but not limited to any type of
swap agreements such as swap agreement under which the Company may provide credit protection to swap counter-
party, any interest and/or currency exchange agreements and other financial derivative agreements.
3.6 The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions
on real estate or on movable property.
4. Duration.
4.1 The Company is incorporated for an unlimited period.
4.2 The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholder(s), voting with the quorum and
majority rules set by the Laws or by the Articles, as the case may be pursuant to Article 27.
Chapter II. - Capital, Shares
5. Share capital.
5.1 The issued capital of the Company is set at thirty-seven thousand five hundred euro (EUR 37,500.-), represented
by twenty-five thousand (25,000) class A ordinary shares (the “Class A Shares”) and twelve thousand five hundred (12,500)
class B ordinary shares (the “Class B Shares”). Each issued share has a nominal value of one euro (EUR 1.-) and is fully
paid-up.
71301
L
U X E M B O U R G
5.2 The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by the
Articles or by the Laws.
5.3 In addition to the issued capital, there may be set up a premium account to which any premium paid on any share
in addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the
payment of any shares which the Company may repurchase from its shareholder(s), to offset any net realised losses, to
make distributions to the shareholder(s) in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve.
6. Shares.
6.1 Each share entitles to one vote.
6.2 The shares may only be in the form of registered shares.
6.3 Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
6.4 Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common representative, whether appointed
amongst them or not.
6.5 When the Company is composed of a single shareholder, the single shareholder may freely transfer its shares.
6.6 When the Company is composed of several shareholders, the shares, except as otherwise provided for in the
Articles and subject to the provisions of any agreement entered into between the shareholders and the Company from
time to time, may be transferred freely amongst shareholders but the shares may be transferred to non-shareholders
only with the authorisation of shareholders representing at least three quarters (3/4) of the capital.
6.7 The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a private contract. Any such transfer is not
binding upon the Company or upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company,
pursuant to article 1690 of the Luxembourg civil code.
6.8 The Company may acquire its own shares with a view to their immediate cancellation.
6.9 Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles and of the resolutions validly adopted by the
shareholder(s).
7. Increase and Reduction of Capital. The issued capital of the Company may be increased or reduced one or several
times by a resolution of the shareholder(s) adopted in compliance with the quorum and majority rules set by the Articles
or, as the case may be, by the Laws for any amendment of the Articles.
8. Incapacity, Death, Suspension of civil rights, Bankruptcy or Insolvency of a Shareholder. The incapacity, death,
suspension of civil rights, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting the shareholder(s) does not put the
Company into liquidation.
Chapter III. - Management
9. Directors.
9.1 The Company shall be managed by a board of directors (conseil de gérance) (the “Board of Directors”) composed
of three (3) directors (gérants), out of which two (2) shall be class A directors (collectively the “Class A Directors” and
individually a “Class A Director”) and one (1) shall be a class B director (the “Class B Director”). The members of the
Board of Directors (collectively the “Directors” and individually a “Director”) need not be shareholders themselves.
9.2 The Class A Directors shall be appointed amongst candidates proposed by the Class A Shareholder(s), while the
Class B Director shall be appointed amongst candidates proposed by the Class B Shareholder(s).
9.3 The Directors will be appointed by the shareholder(s), who will determine the duration of their mandate. The
Directors are eligible for re-appointment.
10. Removal of Directors. A Director may be removed at any time, with or without cause, by a resolution adopted
by the shareholder(s) and any replacement shall be made in accordance with composition and designation rights provided
for in the Articles.
11. Remuneration of Directors. The Directors shall not be compensated for their services as Director, unless other-
wise resolved by the shareholder(s).
12. Powers of the Board of Directors.
12.1 The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for accom-
plishing the Company's object.
12.2 All powers not expressly reserved by the Articles or by the Laws to the shareholder(s) or to the auditor(s) shall
be within the competence of the Board of Directors.
13. Representation of the Company.
13.1 The Board of Directors may delegate special powers or proxies, or entrust determined permanent or temporary
functions to persons or committees chosen by it.
13.2 The Company will be bound towards third parties by the joint signatures of any two (2) Directors.
71302
L
U X E M B O U R G
13.3 The Company will further be bound towards third parties by the joint signatures or sole signature of any person
to whom special power has been delegated by the Board of Directors, but only within the limits of such special power.
14. Meetings of the Board of Directors.
14.1 The Board of Directors shall appoint from among its members a chairman (the “Chairman”). It shall also appoint
from among its members a secretary, who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of
Directors (the “Secretary”).
14.2 The Chairman will be appointed amongst candidates proposed by the Class A Shareholder(s), while the Secretary
shall be appointed amongst candidates proposed by the Class B Shareholder(s).
14.3 The Board of Directors will meet upon call by the Chairman, and in its absence the Secretary, upon request of
any Director.
14.4 The Chairman, and in its absence the Secretary, will preside over all meetings of the Board of Directors.
14.5 Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least seven (7) Business
Days', or if the Board of Directors is due to resolve on the position to be adopted by the Company IC Members in the
Butendiek Investor Committee, at least three (3) Business Days' written notice of meetings of the Board of Directors
shall be given in writing and transmitted by e-mail, courier or fax, except when a meeting is adjourned pursuant to Article
14.13.
14.6 Any such notice shall specify the time and the place of the meeting as well as the agenda and the nature of the
business to be transacted. If the Board of Directors is due to resolve on the position to be adopted by the Company IC
Members in the Butendiek Investor Committee, the notice shall include the agenda and the nature of the business to be
transacted and be accompanied by any relevant documents and be sent as soon as possible after the receipt by the
Company IC Members of the agenda of the Butendiek Investor Committee meeting.
14.7 Within two (2) Business Days, or if the Board of Directors is due to resolve on the position to be adopted by
the Company IC Members in the Butendiek Investor Committee, within one (1) Business Day of the date of the notice
under Article 14.5, any Director may propose an item for inclusion in the agenda together with a related resolution to
be proposed at such meeting.
14.8 If, following the convening of a meeting, any of the Directors indicates to the Chairman on the day of receipt of
the notice for the meeting that it is not available at the time set for the meeting, the Chairman shall, to the extent possible,
endeavour to reschedule the meeting on a different date, taking into account the availability of all Directors.
14.9 Notices may be waived by properly documented consent of each member of the Board of Directors. No separate
notices are required for meetings held at times and places specified in a time schedule previously adopted by resolution
of the Board of Directors.
14.10 The meetings of the Board of Directors shall be held in Luxembourg or, if the circumstances so require, at such
other place as the Board of Directors may from time to time determine in writing.
14.11 Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing, transmitted by any
means of communication allowing for the transmission of a written text, another Director as his proxy. Any Director
may represent one or several members of the Board of Directors.
14.12 A quorum of the Board of Directors shall be the presence or representation of at least half (1/2) of the Directors
holding office.
14.13 In case a quorum is not present within half an hour of the time appointed for the meeting or if a quorum ceases
to be present during the course of the meeting, the Directors present shall adjourn the meeting to a specified date and
time not less than three (3) Business Days after the original date. Notice of the adjourned meeting shall be given to the
Directors in accordance with Article 14.5.
14.14 One or more Directors may participate in a meeting by conference call, videoconference or any other similar
means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each
other. Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting. The decisions and votes made
by any Director participating in a meeting in such a way shall be documented and confirmed by way of e-mails sent to the
Chairman with a copy to each Director.
14.15 A written decision, signed by all the Directors, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting
of the Board of Directors which was duly convened and held. Such a decision may be documented in a single document
or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Directors.
14.16 Decisions will be taken by a majority of the votes of the Directors present or represented at such meeting,
except with respect to Reserved Matters, for which decisions will be taken in accordance with Article 14.17. The Chairman
shall have no casting vote.
14.17 The following matters (the “Reserved Matters”) shall require unanimous prior approval of the Directors present
or represented at the relevant meeting of the Board of Directors:
(i) the decision by the Company to grant any new security or to issue, to amend or, if applicable, to renew (except if
on the same terms) any security required by any shareholder undertaking agreement as entered into from time to time;
71303
L
U X E M B O U R G
(ii) the decision to deviate from the debt/equity ratio of capital contributions by the shareholder(s) as set out in any
agreement entered into by the shareholder(s) and the Company from time to time;
(iii) the setting up, ceasing of activity of, winding up or liquidation (other than in case of liquidation induced by the
Class A Shareholder(s) pursuant to the provisions of any agreement entered into between the shareholders and the
Company from time to time) of the Company, as well as any transactions transferring all or part of the shares of or any
material assets of the Company (including any restructuring transactions including mergers, demergers, contributions of
businesses involving the Company) or application for the opening of any judicial pre-insolvency or insolvency proceedings
for the Company;
(iv) a change to the general nature of the business of the Company, including but not limited to entering into new lines
of business that are inconsistent with the current business model;
(v) all transactions which bind the Company for a sum of more than one hundred thousand euro (EUR 100,000.-);
(vi) all deeds and transactions with a shareholder or an Affiliate to a shareholder;
(vii) the sale, transfer or disposal of all or part of the Butendiek Stake or its enlargement;
(viii) any proposal of annual accounts of the Company submitted for approval to the general meeting of shareholders;
(ix) the entry into any employment contract or consultancy agreement; and
(x) the position to be adopted by the Company in the Butendiek Partners' Meeting on any matter requiring prior
approval of the partners under any partnership agreement as entered into from time to time.
14.18 The approval of the Board of Directors shall not be required for any of the Reserved Matters if it has already
been unanimously approved by the shareholders.
14.19 To the extent that the implementation of a decision on any of the Reserved Matters as listed in Article 14.17
requires by law a decision of the shareholder(s), the decision taken by the Board of Directors pursuant to Article 14.17
shall be limited to a proposal for a decision by the shareholders on the respective Reserved Matters which shall be
submitted for approval to the general meeting of shareholders.
15. Directors' Liability - Indemnification.
15.1 No Director commits himself, by reason of his functions, to any personal obligation in relation to the commitments
taken on behalf of the Company.
15.2 Directors are only liable for the performance of their duties.
16. Auditors.
16.1 Except where according to the Laws, the Company's annual statutory and/or consolidated accounts must be
audited by an approved statutory auditor, the business of the Company and its financial situation, including in particular
its books and accounts, may, and shall in the cases provided by law, be reviewed by one or more statutory auditors who
need not be shareholders themselves.
16.2 The statutory or approved statutory auditors, if any, will be appointed by the shareholder(s), which will determine
the number of such auditors and the duration of their mandate. They are eligible for re-appointment. They may be
removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholder(s), save in such cases where the approved
statutory auditor may, as a matter of the Laws, only be removed for serious cause or by mutual agreement.
Chapter IV. - General meeting of shareholders
17. Powers of the shareholders.
17.1 The shareholder(s) shall have such powers as are vested in them pursuant to the Laws, the Articles and in any
agreement entered into between the shareholder(s) and the Company from time to time.
17.2 Any properly constituted general meeting of shareholders of the Company represents the entire body of share-
holders.
18. Annual General Meeting.
18.1 The annual general meeting of shareholders, of which one must be held where the Company has more than
twenty-five (25) shareholders, will be held each year on the last Thursday of May.
18.2 If such day is a day on which banks are not generally open for business in Luxembourg, the meeting will be held
on the next following Business Day.
19. Other General Meetings.
19.1 The holding of general meetings shall not be obligatory where the number of shareholders does not exceed
twenty-five (25). In such case, each shareholder shall receive the precise wording of the text of the resolutions or decisions
to be adopted and shall give his vote in writing.
19.2 General meetings of shareholders, including the annual general meeting of shareholders will be held at the regis-
tered office of the Company or at such other place in the Grand Duchy of Luxembourg, and may be held abroad if, in
the judgement of the Directors, which is final, circumstances of force majeure so require.
71304
L
U X E M B O U R G
20. Notice of General Meetings.
20.1 Unless there is only one single shareholder, the shareholders may also meet in a general meeting of shareholders
upon issuance by the Chairman, of a convening notice in compliance with the Articles or the Laws, (i) upon request by
any of the shareholders and, (ii) in cases where the interest of the Company requires it.
20.2 A general meeting of shareholders may further be convened by the Directors and, subsidiarily, by the statutory
auditor(s) (if any).
20.3 A ten (10) Business Days' convening notice sent to the shareholders will specify the time and the place of the
meeting as well as the agenda, the nature of the business to be transacted at the relevant general meeting of shareholders
and the wording of the proposed resolutions (if any). The agenda for a general meeting of shareholders shall also, where
appropriate, describe any proposed changes to the Articles and, if applicable, set out the text of those changes affecting
the object or form of the Company.
20.4 The notice period shall start upon receipt of such notice by the shareholders. If all the shareholders are present
or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they have been duly informed of the agenda of
the meeting, the meeting may be held without prior notice. All notices, shall be deemed to have been duly given if signed
by the respective persons giving them and delivered by hand, or deposited in the mail (registered, return receipt reques-
ted), properly addressed and postage prepaid or by facsimile (provided the same is confirmed by mail, as above sent within
one (1) day of dispatch) or by e-mail (confirmation of receipt requested) to the address of the shareholder.
20.5 Each shareholder shall be entitled to submit agenda topics for the general meeting on which the shareholders
have to resolve upon. Such requests must be received by the Chairman, or, in case the Chairman is unavailable, the
Secretary, in written form at least four (4) Business Days prior to the general meeting and such request shall complement
the current agenda in chronological order. The Chairman, or, in case the Chairman is unavailable, the Secretary shall
inform the shareholders without undue delay of such new agenda topics.
21. Attendance - Representation.
21.1 All shareholders are entitled to attend and speak at any general meeting of shareholders.
21.2 A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing in writing, transmitted by any means
of communication allowing for the transmission of a written text, another person who need not be a shareholder himself,
as a proxy holder.
22. Proceedings.
22.1 Any general meeting of shareholders shall be presided over by the Chairman or by a person designated by the
Directors or, in the absence of such designation, by the general meeting of shareholders.
22.2 The chairman of the general meeting of shareholders shall appoint a secretary.
22.3 The general meeting of shareholders shall elect one (1) scrutineer to be chosen from the persons attending the
general meeting of shareholders.
22.4 The Chairman, the secretary and the scrutineer so appointed together form the board of the general meeting.
23. Vote.
23.1 At any general meeting of shareholders other than a general meeting convened for the purpose of amending the
Articles or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum and majority requirements set for an amend-
ment to the Articles, resolutions shall be adopted by a simple majority of votes cast.
23.2 At any general meeting of shareholders, convened in accordance with the Articles or the Laws, for the purpose
of (i) amending the Articles, (ii) approving the annual accounts of the Company, or (iii) approving a transfer by a share-
holder of shares in the Company to a third party, the majority requirements shall, in addition to legal requirements, be
a majority of at least three quarters (3/4) of the capital.
24. Minutes.
24.1 The minutes of the general meeting of shareholders shall be signed by the shareholders present and may be signed
by any shareholders or proxies of shareholders, who so request.
24.2 The resolutions adopted by the single shareholder shall be documented in writing and signed by the single sha-
reholder.
24.3 Copies or extracts of the written resolutions adopted by the shareholders as well as of the minutes of the general
meeting of shareholders to be produced in judicial proceedings or otherwise may be signed by any two (2) Directors
acting jointly.
Chapter V. - Business year
25. Business year.
25.1 The Company's financial year starts on the first day of January and ends on the last day of December each year.
25.2 At the end of each financial year, the Company's accounts are established by the Board of Directors and the
Board of Directors prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.
25.3 Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
71305
L
U X E M B O U R G
26. Distribution of Profits.
26.1 The profits in respect of a financial year, after deduction of general and operating expenses, charges and depre-
ciations, shall constitute the net profit of the Company in respect of that period.
26.2 From the net profit thus determined, five per cent (5%) shall be deducted and allocated to a legal reserve fund.
That deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal reserve fund reaches ten per cent (10%) of the
Company's nominal capital.
26.3 To the extent that funds are available at the level of the Company for distribution and to the extent permitted
by law and by these Articles, the Board of Directors shall propose that cash available for remittance be distributed.
26.4 The decision to distribute funds and the determination of the amount of such a distribution will be taken by the
general meeting of the shareholders.
26.5 Interim dividends may be distributed by the Board of Directors in accordance with the law and provided each
time that the Board of Directors has previously taken every measure necessary in order to ascertain the existence of
distribuable sums within the meaning of the law.
Chapter VI. - Liquidation
27. Liquidation.
27.1 The liquidation of the Company can only be decided in accordance with the Laws and the provisions of any
agreement entered into between the Company and the shareholders from time to time.
27.2 The liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the share-
holders who shall determine their powers and remuneration.
Chapter VII. - Applicable law
28. Applicable law. Reference is made to the provisions of the Laws for all matters for which no specific provision is
made in these Articles.
Chapter VIII. - Definitions
29. Definitions. The following terms, when capitalized, will have the meaning ascribed to them in this Article:
Affiliate
means any corporation which, in relation to the person concerned (if a corporation),
controls (directly or indirectly) such person or is controlled (directly or indirectly)
by such person or by a corporation controlling (directly or indirectly) such person;
for these purposes “Control” means (i) the holding of a majority of the voting rights
or the right to exercise such majority of voting rights pursuant to an agreement; or
(ii) the right to nominate or elect a majority of the members of the board of directors;
provided that, unless otherwise expressly provided in any agreement entered into
between the Company and the shareholders from time to time, the Company shall
neither be deemed to be the Class A Shareholder(s)' Affiliate nor the Class B
Shareholder(s)' Affiliate. For the avoidance of doubt, an Affiliate within the meaning
shall also be (i) any company or fund which is managed or advised by a company
which is an Affiliate of the Class B Shareholder(s) or (ii) any company or fund which
is managed or advised by a company which is an Affiliate of the Class A Shareholder
(s).
Articles
has the meaning set forth in Article 1.1.
Board of Directors
has the meaning set forth in Article 9.1.
Business Day
means a day on which banks are generally open for business in Luxembourg and
France, except in the case of Article 14 where it shall mean a day on which banks
are generally open for business in Germany.
Butendiek Investor Committee means a corporate body at the level of the Project Company composed of
representatives of its limited partners.
Butendiek Partners' Meeting
means the partners' meeting of the Project Company.
Butendiek Stake
means a participation held by the Company in the Project Company in the form of
a limited partner's interest.
Company
has the meaning set forth in Article 1.1.
Class A Directors
has the meaning set forth in Article 9.1.
Class B Director
has the meaning set forth in Article 9.1.
Class A Shareholder
means the holder of Class A Share(s).
Class A Shares
has the meaning set forth in Article 5.1.
Class B Shareholder
means the holder of Class B Share(s).
Class B Shares
has the meaning set forth in Article 5.1.
Company IC Members
means two members of the Butendiek Investor Committee nominated by the
71306
L
U X E M B O U R G
Company.
Director
has the meaning set forth in Article 9.1.
Directors
has the meaning set forth in Article 9.1.
General Partner
means OWP Butendiek Verwaltungs GmbH.
Laws
has the meaning set forth in Article 1.1.
Project Company
OWP Butendiek GmbH & Co. KG, a special purpose vehicle in the legal form of a
German limited partnership with a German limited liability company as general
partner.
Reserved Matters
has the meaning set forth in Article 14.17.
“
<i>Second resolutioni>
The Shareholders resolved to re-qualify (i) the twenty-five thousand (25,000) ordinary shares with a nominal value of
one euro (EUR 1.-) each held by Marguerite Holdings S.à r.l. into twenty-five thousand (25,000) class A ordinary shares
with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each and (ii) twelve thousand five hundred (12,500) ordinary shares held by
CDC Infrastructure with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each into twelve thousand five hundred (12,500) class B
ordinary shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each.
<i>Third resolutioni>
The Shareholders resolved to accept the resignations of Nicolas Merigo, director (gérant) and Michael Dedieu, director
(gérant), with effect as of the date hereof.
<i>Fourth resolutioni>
The Shareholders resolved to set the number of directors (gérants) of the Company at three (3), out of which two
(2) shall be class A directors (gérants) and one (1) shall be a class B director (gérant).
<i>Fifth resolutioni>
The Shareholders resolved to redesignate the existing directors (gérants), David Harrison and William Pierson, as
class A directors (gérants) of the Company for an unlimited duration, with effect as of the date hereof.
<i>Sixth resolutioni>
The Shareholders resolved to appoint Julien Gailleton, investment director at CDC Infra, born in Tassin-la-Demi-Lune,
France, on 26 February 1979, and residing at 7, avenue Rachel, 75018 Paris, France, as class B director (gérant) of the
Company for an unlimited duration, with effect as of the date hereof.
<i>Seventh resolutioni>
The Shareholders resolved to set at one (1) the number of auditors and further resolved to appoint the following
company for a period starting with the audit of the financial statements for the period ending on 31 December 2013 and
ending at the annual general meeting of shareholders approving the annual accounts of the financial year ending on 31
December 2014:
Artemis Audit & Advisory, a société à responsabilité limitée, having its registered seat at 25 A, Boulevard Royal, L -
2449 Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Trade and Companies under number B166716.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed
are estimated at one thousand five hundred euro (EUR 1,500.-).
There being no other business on the agenda, the meeting was adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case
of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.
Whereupon, the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the
beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, who are known to the undersigned notary by their surname,
first name, civil status and residence, such persons signed together with the undersigned notary, this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille treize, le cinquième jour du mois de décembre,
par devant nous, Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,
ont comparu:
71307
L
U X E M B O U R G
(1) Marguerite Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant un capital
social de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-), dont le siège social est au 1-3, boulevard de la Foire, L-1528 et enregistrée
auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 162622 (“Marguerite”); et
(2) CDC Infrastructure, une société anonyme régie par le droit français, dont le siège social est au 56, rue de Lille,
F-75007 Paris, et enregistrée sous le numéro 450 055 090 (“CDC Infra”).
Marguerite est représentée aux fins des présentes par David S. HARRISON et Michael DEDIEU, agissant en tant que
gérants.
CDC Infra est représentée aux fins des présentes par Patrick Vandevoorde, Directeur Général.
Les parties mentionnées ci-dessus sont collectivement référencées comme étant les «Associés».
Les Associés ont demandé au notaire soussigné d'acter que les Associés sont tous les associés de Marguerite Wind
Butendiek S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, avec un capital social de trente-
sept mille cinq cents euros (EUR 37.500,-), ayant son siège social au 1-3, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 172706 (la «Société»), constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, du 8 novembre 2012 publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 11 décembre 2012, numéro 2996. Les statuts de la Société ont été
modifiés pour la dernière fois suivant un acte du notaire soussigné, du 29 novembre 2013, non encore publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations.
Les Associés, représentés tel que mentionné ci-dessus, reconnaissent avoir été dûment et pleinement informés des
résolutions à prendre sur la base de l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Modifier intégralement les statuts de la Société sans modifier l'objet social de la Société, afin de, entre autre chose,
convertir les parts sociales ordinaires en parts sociales ordinaires de catégorie A et parts sociales ordinaires de catégorie
B, déterminer les droits et obligations attachés aux parts sociales, supprimer le capital autorisé, classifier les gérants en
gérants de catégorie A et gérants de catégorie B, modifier les règles sur le représentation de la Société, introduire le
concept de “Questions Réservées”, nommer un commissaire et définir les règles de gouvernance de la Société.
2. Re-qualifier (i) les vingt-cinq mille (25.000) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-)
chacune détenues par Marguerite Holdings S.à r.l. en vingt-cinq mille (25.000) parts sociales ordinaires de catégorie A
ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, et (ii) les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ordinaires
ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune détenues par CDC Infrastructure en douze mille cinq cents
(12.500) parts sociales ordinaires de catégorie B ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune.
3. Accepter la démission de Nicolas Merigo, gérant et de Michael Dedieu, gérant.
4. Fixer le nombre des gérants à trois (3), comprenant deux (2) gérants de catégorie A et un (1) gérant de catégorie
B.
5. Requalifier les gérants existants en tant que gérants de catégorie A pour une durée illimitée.
6. Nommer Julien Gailleton en tant que gérant de catégorie B pour une durée illimitée.
7. Fixer le nombre des commissaires à un (1) et nommer Artemis en tant que commissaire pour une période prenant
fin lors de l'assemblée générale annuelle des associés approuvant les comptes annuels de l'exercice social se terminant le
31 décembre 2014.
8. Divers.
Les Associés ont adopté les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les Associés ont décidé de modifier intégralement les statuts de la Société, sans modifier l'objet social de la Société,
afin de, entre autre chose, convertir les parts sociales ordinaires en parts sociales ordinaires de catégorie A et parts
sociales ordinaires de catégorie B, déterminer les droits et obligations attachés aux parts sociales, supprimer le capital
autorisé, classifier les gérants en gérants de catégorie A et gérants de catégorie B, modifier les règles sur le représentation
de la Société, introduire le concept de “Questions Réservées”, nommer un commissaire et définir les règles de gouver-
nance de la Société.
Les statuts de la Société seront désormais rédigés de la manière suivante:
«Titre I
er
. - Forme, Nom, Siège social, Objet, Durée
1. Forme - Dénomination.
1.1 Il existe une société à responsabilité limitée (la «Société») régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg (les
«Lois»), ainsi que par les présents statuts (les «Statuts»).
1.2 La Société peut comporter un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales, ou plusieurs associés
dans la limite de quarante (40) associés.
1.3 La Société porte la dénomination «Marguerite Wind Butendiek S.à r.l.».
71308
L
U X E M B O U R G
2. Siège social.
2.1 Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.
2.2 Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l'assemblée
générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
2.3 Toutefois, le Conseil de Gérance de la Société est autorisé à transférer le siège social de la Société à l'intérieur de
la Ville de Luxembourg.
2.4 Au cas où des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social de nature à com-
promettre l'activité normale au siège social de la Société se seraient produits ou seraient imminents, le siège social pourra
être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure
provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège,
restera luxembourgeoise. La décision de transférer le siège social à l'étranger sera prise par le Conseil de Gérance.
3. Objet.
3.1 L'objet de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembour-
geoises et étrangères, l'acquisition par l'achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par vente,
échange ou autre, d'actions, d'obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres instruments de capital ou de
dettes (convertibles ou non) de quelque forme que ce soit (y compris, sans que cela soit limitatif, des titres de couverture
synthétique), et la propriété, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut en outre
prendre des participations dans des sociétés de personnes.
3.2 La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations, de reconnaissances de
dettes ainsi que tous autres types d'instruments de capital ou de dettes (convertibles ou non).
3.3 D'une façon générale, elle peut accorder une assistance directe ou indirecte aux sociétés affiliées ou aux sociétés
du groupe (y compris, sans que cela soit limitatif, l'octroi de tout type de prêt), prendre toutes mesures de contrôle et /
ou de supervision et accomplir toute opération qui pourrait être utile à l'accomplissement et au développement de son
objet.
3.4 La Société pourra notamment accorder toutes garanties, mettre en gage ou fournir toutes autres formes de sûretés,
que ce soit par engagement personnel ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des actifs (présents ou futurs) de
l'entreprise, ou par l'une ou l'autre de ces méthodes, pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou
de toute société apparentée ou du groupe ou de tout administrateur, gérant ou autre mandataire de la Société ou de
toute société apparentée ou du groupe, dans les limites de la loi.
3.5 La Société pourra conclure toute forme de contrats de crédit dérivés, en ce compris, sans que cela soit limitatif,
tout type de contrat de swap, tel que des contrats de swap en vertu desquels la Société fournira une protection de crédit
à la contre - partie, tout contrat d'échange sur devises ou taux d'intérêts et tout autre contrat sur des produits dérivés.
3.6 La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute
transaction sur des biens mobiliers ou immobiliers.
4. Durée.
4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2 La Société peut être dissoute à tout moment par une résolution des associés, statuant aux conditions de quorum
et de majorité requises par les Lois ou par les Statuts, le cas échéant conformément à l'Article 27.
Titre II. - Capital, Parts sociales
5. Capital social.
5.1 Le capital social de la Société est fixé à trente-sept mille cinq cents euros (EUR 37.500,-), représenté par vingt-cinq
mille (25.000) parts sociales ordinaires de catégorie A (les «Parts Sociales de Catégorie A») et douze mille cinq cents
(12.500) parts sociales ordinaires de catégorie B (les «Parts Sociales de Catégorie B»). Chaque part sociale émise a une
valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) et est entièrement libérée.
5.2 Les droits et obligations attachés aux parts sociales sont identiques sauf stipulation contraire des Statuts ou des
Lois.
5.3 En plus du capital émis, un compte prime d'émission peut être établi sur lequel seront transférées toutes les primes
d'émission payées sur les parts sociales en plus de la valeur nominale. Le solde de ce compte prime d'émission peut être
utilisé pour régler le prix des parts sociales que la Société a rachetées à ses associés, pour compenser toute perte nette
réalisée, pour distribuer des dividendes aux associés ou pour affecter des fonds à la réserve légale.
6. Parts Sociales.
6.1 Chaque part sociale donne droit à une voix.
6.2 Les parts sociales revêtiront la forme nominative.
6.3 Chaque part sociale est indivisible à l'égard de la Société.
6.4 Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un représentant
commun désigné ou non parmi eux.
71309
L
U X E M B O U R G
6.5 Lorsque la Société se compose d'un seul associé, l'associé unique peut librement céder ses parts sociales.
6.6 Lorsque la Société compte plusieurs associés, sauf dispositions contraires des statuts et sous réserve des conditions
fixées dans tout contrat conclu entre les associés et la Société de temps à autre, les parts sociales sont librement cessibles
entre eux et les parts sociales ne peuvent être cédées à des non-associés qu'avec l'autorisation des associés représentant
au moins les trois quarts (3/4) du capital social.
6.7 Le transfert des parts sociales doit être constaté par un acte notarié ou par un acte sous seing privé. Une telle
cession n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après avoir été dûment notifiée à la Société ou acceptée par la Société,
conformément à l'article 1690 du code civil luxembourgeois.
6.8 La Société peut acquérir ses propres parts sociales en vue de leur annulation immédiate.
6.9 La propriété d'une part sociale emporte de plein droit adhésion aux Statuts et aux résolutions valablement adoptées
par les associés.
7. Augmentation et Réduction de Capital. Le capital émis de la Société peut être augmenté ou réduit, en une ou
plusieurs fois, par une résolution des associés adoptée aux conditions de quorum et de majorité requises par les Statuts
ou, le cas échéant, par les Lois pour toute modification des Statuts.
8. Incapacité, Décès, Suspension des droits civils, Faillite ou Insolvabilité d'un Associé. L'incapacité, le décès, la sus-
pension des droits civils, la faillite, l'insolvabilité ou tout autre événement similaire affectant un associé n'entraîne pas la
mise en liquidation de la Société.
Titre III. - Gérance
9. Gérants.
9.1 La Société est gérée et administrée par un conseil de gérance (le «Conseil de Gérance») composé de trois (3)
gérants, dont deux (2) devront être gérants de catégorie A (collectivement les «Gérants de Catégorie A» et individuel-
lement le «Gérant de Catégorie A») et un (1) devra être gérant de catégorie B (le «Gérant de Catégorie B»). Les membres
du Conseil de Gérance (collectivement les «Gérants» et individuellement un «Gérant») n'ont pas besoin d'être associés.
9.2 Les Gérants de Catégorie A seront nommés parmi les candidats proposés par les Associés de Catégorie A, tandis
que le Gérant de Catégorie B sera nommé parmi les candidats proposés par les Associés de Catégorie B.
9.3 Les Gérants seront nommés par les associés, qui détermineront la durée de leur mandat. Le mandat des Gérants
pourra être renouvelé.
10. Révocation des Gérants. Un Gérant pourra être révoqué à tout moment, avec ou sans motif, par une résolution
des associés et tout remplacement devra être fait en conformité avec les droits de composition et de désignation prévus
par les Statuts.
11. Rémunération des Gérants. Les Gérants ne seront pas rémunérés pour leurs services en tant que Gérant, sauf s'il
en est décidé autrement par les associés.
12. Pouvoirs du Conseil de Gérance.
12.1 Le Conseil de Gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou
utiles à l'accomplissement de l'objet de la Société.
12.2 Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par les Statuts ou par les Lois aux associés ou au(x)
commissaire(s) relèvent de la compétence du Conseil de Gérance.
13. Représentation de la Société.
13.1 Le Conseil de Gérance peut déléguer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions spécifiques permanentes
ou temporaires à des personnes ou des comités de son choix.
13.2 La Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux (2) Gérants.
13.3 La Société sera également engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou par la signature individuelle de
toute personne à qui ce pouvoir de signature aura été délégué par les Gérants, mais seulement dans les limites de ce
pouvoir.
14. Réunions du Conseil de Gérance.
14.1 Le Conseil de Gérance désigne parmi ses membres un président (le «Président»). Il nomme également parmi ses
membres un secrétaire, qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance (le
«Secrétaire»).
14.2 Le Président sera nommé parmi les candidats proposés par les Associés de Catégorie A, tandis que le Secrétaire
sera nommé parmi les candidats proposés par les Associés de Catégorie B.
14.3 Le Conseil de Gérance se réunira sur convocation du Président et, en son absence, du Secrétaire, à la demande
de tout Gérant.
14.4 Le Président, et en son absence, le Secrétaire, présidera toutes les réunions du Conseil de Gérance.
71310
L
U X E M B O U R G
14.5 Sauf en cas d'urgence ou avec l'accord préalable de tous ceux qui ont le droit d'y assister, sept (7) Jours Ouvrables
au moins avant la date prévue pour la réunion du Conseil de Gérance, ou si le Conseil de Gérance doit se prononcer sur
la position devant être adoptée par les Membres IC de la Société au sein du Comité des Investisseurs Butendiek, trois
(3) Jours Ouvrables au moins avant la date prévue pour la réunion du Conseil de Gérance, une convocation écrite devra
être transmise par e-mail, porteur ou fax, sauf si une réunion est ajournée conformément à l'Article 14.13.
14.6 Toute convocation écrite doit préciser la date et le lieu de la réunion ainsi que l'ordre du jour et la nature des
affaires à traiter. Si le Conseil de Gérance est convoqué pour se prononcer sur la position devant être adoptée par les
Membres IC de la Société au sein du Comité des Investisseurs Butendiek, l'avis doit comporter l'ordre du jour et la nature
des affaires à traiter et doit être accompagné de tout document utile et doit être envoyé dès que possible après la réception
par les Membres IC de la Société de l'ordre du jour de la réunion du Comité des Investisseurs Butendiek.
14.7 Dans les deux (2) Jours Ouvrables ou, si le Conseil de Gérance doit se prononcer sur la position devant être
adoptée par les Membres IC de la Société au sein du Comité des Investisseurs Butendiek, le lendemain de la date de la
convocation prévue à l'Article 14.5, tout Gérant peut proposer un point à inclure dans l'ordre du jour ainsi qu'une
résolution correspondante qui sera soumise au vote lors de la réunion.
14.8 Si à la suite de la convocation d'une réunion, un Gérant indique au Président le jour de la réception de la convo-
cation qu'il n'est pas disponible à la date fixée pour la réunion, le Président doit, dans la mesure du possible, faire en sorte
de reporter la réunion à une date différente, en tenant compte de la disponibilité de tous les Gérants.
14.9 Il pourra être renoncé à la convocation par un accord correctement consigné de chaque membre du Conseil de
Gérance. Aucune convocation spéciale ne sera requise pour les réunions se tenant à des dates et des lieux déterminés
préalablement par une résolution adoptée par le Conseil de Gérance.
14.10 Toutes les réunions du Conseil de Gérance se tiendront à Luxembourg ou, si les circonstances l'exigent, à tout
autre endroit que le Conseil de Gérance pourra déterminer par écrit de temps à autre.
14.11 Tout Gérant est autorisé à se faire représenter lors d'une réunion du Conseil de Gérance en désignant par écrit,
transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit, un autre Gérant comme son
mandataire. Tout Gérant peut représenter un ou plusieurs membres du Conseil de Gérance.
14.12 Le Conseil de Gérance ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié (1/2) des Gérants en fonction
est présente ou représentée.
14.13 Dans le cas où le quorum n'est pas atteint dans la demi-heure de l'heure fixée pour la réunion ou si le quorum
cesse d'être atteint au cours de la réunion, les Gérants présents devront ajourner la réunion à une date et une heure se
situant au moins trois (3) Jours Ouvrables après la date initiale. La convocation de la réunion ajournée devra être donnée
aux Gérants conformément à l'Article 14.5.
14.14 Un ou plusieurs Gérants peuvent prendre part à une réunion par conférence téléphonique, visioconférence ou
tout autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer
simultanément les unes avec les autres. Une telle participation sera considérée équivalente à une présence physique à la
réunion. Les décisions et les votes émis par un Gérant participant ainsi à une réunion doivent être documentés et con-
firmés au moyen d'un courrier électronique envoyé au Président, avec copie à chacun des Gérants.
14.15 Une décision écrite, signée par tous les Gérants, est régulière et valable de la même manière que si elle avait
été adoptée à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être consignée
dans un seul ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu et signé par un ou plusieurs Gérants.
14.16 Les décisions seront prises à la majorité des voix des Gérants présents ou représentés à cette réunion, sauf en
ce qui concerne les Affaires Réservées, pour lesquelles les décisions seront prises conformément à l'Article 14.17. Le
Président n'a pas de voix prépondérante.
14.17 Les sujets suivants (les «Affaires Réservées») exigent l'approbation préalable et unanime des Gérants présents
ou représentés à la réunion concernée du Conseil de Gérance:
(i) la décision de la Société d'accorder une nouvelle sûreté ou d'émettre, de modifier ou, le cas échéant, de renouveler
(sauf si cela est fait dans les mêmes conditions) toute sûreté requise par tout accord d'engagements d'associés conclu de
temps à autre;
(ii) la décision de s'écarter du ratio d'endettement en ce qui concerne les apports en capital par les associés tel que
fixé dans tout accord conclu par les associés et la Société de temps à autre;
(iii) la mise en place, la cessation d'activité ou la liquidation (sauf en cas de liquidation provoquée par les Associés de
Catégorie A conformément aux dispositions de tout accord conclu entre les associés et la Société de temps à autre) de
la Société, ainsi que toutes les opérations consistant à transférer tout ou partie des parts sociales ou d'actifs importants
de la Société (y compris toute opération de restructuration et notamment les fusions, scissions, apports d'entreprises
impliquant la Société) ou de la demande d'ouverture d'une procédure collective ou de faillite pour la Société;
(iv) la modification de la nature générale de l'objet de la Société, y compris sans que cela soit limitatif, l'entrée dans de
nouveaux secteurs d'activité incohérents avec le modèle économique actuel;
(v) toutes les opérations qui obligent la Société pour un montant qui s'élève à plus de cent mille euros (EUR 100.000,-);
(vi) tous les actes et opérations avec un associé ou un Affilié d'un associé;
(vii) la cession ou le transfert de tout ou partie de la Participation Butendiek ou son augmentation;
71311
L
U X E M B O U R G
(viii) tout projet de comptes annuels de la Société soumis à l'approbation de l'assemblée générale des associés;
(ix) la conclusion de tout contrat de travail ou contrat de consultant; et
(x) la position à adopter par la Société lors de l'Assemblée des Associés Butendiek concernant toute question néces-
sitant l'approbation préalable des associés conformément à tout accord de partenariat conclu de temps à autre.
14.18 L'approbation du Conseil de Gérance ne sera pas nécessaire pour les Affaires Réservées déjà approuvées à
l'unanimité par les associés.
14.19 Dans tous les cas où la loi requiert une décision des associés pour la mise en oeuvre de toute décision concernant
les Affaires Réservées énumérées à l'Article 14.17, la décision prise par le Conseil de Gérance conformément à l'Article
14.17 devra être limitée à une proposition en vue d'une résolution des associés sur les Affaires Réservées concernées
qui devra être soumise à l'approbation de l'assemblée générale des associés.
15. Responsabilité des Gérants - Indemnité.
15.1 Les Gérants n'engagent pas leur responsabilité personnelle lorsque, dans l'exercice de leurs fonctions, ils prennent
des engagements pour le compte de la Société.
15.2 Les Gérants sont uniquement responsables de l'accomplissement de leurs devoirs.
16. Commissaires.
16.1 Sauf lorsque, conformément aux Lois, les comptes annuels et/ou les comptes consolidés de la Société doivent
être vérifiés par un réviseur d'entreprises agréé, les affaires de la Société et sa situation financière, en particulier ses
documents comptables, peuvent et devront, dans les cas prévus par la loi, être contrôlés par un ou plusieurs commissaires
qui n'ont pas besoin d'être eux-mêmes associés.
16.2 Le(s) commissaire(s) ou réviseur(s) d'entreprises agréé(s) seront, le cas échéant, nommés par les associés qui
détermineront leur nombre et la durée de leur mandat. Leur mandat peut être renouvelé. Ils peuvent être révoqués à
tout moment, avec ou sans motif, par une résolution des associés sauf dans les cas où le réviseur d'entreprises agréé peut
seulement, par dispositions des Lois, être révoqué pour motifs graves ou d'un commun accord.
Titre IV. - Assemblée générale des associés
17. Pouvoirs des associés.
17.1 Les associés exercent les pouvoirs qui leur sont dévolus par les Statuts, les Lois et tout accord conclu entre les
associés et la Société de temps à autre.
17.2 Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée représente l'ensemble des associés.
18. Assemblée générale annuelle.
18.1 L'assemblée générale annuelle des associés, qui doit se tenir au cas où la Société a plus de vingt-cinq (25) associés,
aura lieu le dernier jeudi du mois de mai de chaque année.
18.2 Si ce jour n'est pas généralement un jour bancaire ouvrable à Luxembourg, l'assemblée se tiendra le premier Jour
Ouvrable suivant.
19. Autres assemblées générales.
19.1 La tenue des assemblées générales n'est pas obligatoire quand le nombre des associés n'est pas supérieur à vingt-
cinq (25). Dans ce cas, chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre et émettra son vote par
écrit.
19.2 Les assemblées générales des associés, y compris l'assemblée générale annuelle des associés se tiendront au siège
social de la Société ou à tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg, et peuvent être tenues à l'étranger si, de
l'avis des Gérants, qui est définitif, des circonstances de force majeure l'exigent.
20. Convocation des Assemblées Générales.
20.1 A moins qu'il n'y ait qu'un associé unique, les associés peuvent aussi se réunir en assemblées générales, confor-
mément aux conditions fixées par les Statuts ou les Lois, sur convocation du Président, (i) à la suite d'une demande d'un
associé et (ii) dans les cas où l'intérêt de la Société l'exige.
20.2 Une assemblée générale des associés peut également être convoquée par les Gérants et, subsidiairement, par le
ou les commissaires (s'il en existe).
20.3 Une convocation envoyée dix (10) Jours Ouvrables avant la date prévue pour l'assemblée aux associés indiquera
la date et le lieu de la réunion ainsi que l'ordre du jour, la nature des affaires à traiter lors de l'assemblée générale des
associés et, le cas échéant, le libellé des résolutions proposées. L'ordre du jour d'une assemblée générale des associés
doit également, le cas échéant, décrire toute proposition de modifications aux Statuts et, le cas échéant, préciser le texte
des changements affectant l'objet ou la forme de la Société.
20.4 Le délai de convocation commence à courir à la réception de la convocation par les associés. Si tous les associés
sont présents ou représentés à une assemblée générale des associés et s'ils déclarent avoir été dûment informés de l'ordre
du jour de la réunion, la réunion peut être tenue sans convocation préalable. Toutes les convocations sont réputées avoir
été effectivement transmises si elles sont signées par les personnes les ayant remises en main propre, ou envoyées par
71312
L
U X E M B O U R G
courrier (recommandé, avec accusé de réception), correctement adressé et affranchi, ou par télécopieur (à condition
que la convocation soit confirmée par courrier, comme indiqué ci-dessus, envoyé comme indiqué ci-avant le lendemain
de l'envoi) ou par courrier électronique (avec demande de confirmation de réception) à l'adresse de l'associé.
20.5 Chaque associé aura le droit de soumettre des sujets à l'ordre du jour de l'assemblée générale sur lesquels les
associés devront se prononcer. Ces demandes doivent être reçues par le Président, ou, dans le cas où le Président est
indisponible, le Secrétaire, sous forme écrite au moins quatre (4) Jours Ouvrables avant l'assemblée générale, cette
demande devant compléter l'ordre du jour actuel dans un ordre chronologique. Le Président, ou, dans le cas où le
Président est indisponible, le Secrétaire, informe les associés sans délai des nouveaux sujets à l'ordre du jour.
21. Présence - Représentation.
21.1 Tous les associés sont en droit de participer et de prendre la parole à toute assemblée générale des associés.
21.2 Un associé peut désigner par écrit, transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d'un
texte écrit, un mandataire qui n'a pas besoin d'être lui-même associé.
22. Procédure.
22.1 Toute assemblée générale des associés est présidée par le Président ou par une personne désignée par les Gérants,
ou, faute d'une telle désignation par les Gérants, par une personne désignée par l'assemblée générale des associés.
22.2 Le Président de l'assemblée générale des associés désigne un secrétaire.
22.3 L'assemblée générale des associés élit un (1) scrutateur parmi les personnes participant à l'assemblée générale
des associés.
22.4 Le Président, le secrétaire et le scrutateur ainsi désignés forment ensemble le bureau de l'assemblée générale.
23. Vote.
23.1 Lors d'une assemblée générale des associés autre qu'une assemblée générale convoquée en vue de la modification
des Statuts ou du vote de résolutions dont l'adoption est soumise aux conditions de quorum et de majorité requises pour
une modification des Statuts, les résolutions seront adoptées à la majorité simple des voix exprimées.
23.2 Lors d'une assemblée générale des associés, convoquée conformément aux Statuts ou aux Lois, en vue de (i) la
modification des Statuts, (ii) l'approbation des comptes annuels de la Société, ou (iii) l'approbation de la cession par un
associé de parts sociales dans la Société à un tiers, la majorité requise, en plus des exigences légales, sera une majorité
d'au moins les trois quarts (3/4) du capital social.
24. Procès-verbaux.
24.1 Les procès-verbaux des assemblées générales doivent être signés par les associés présents et peuvent être signés
par tous les associés ou mandataires d'associés qui en font la demande.
24.2 Les résolutions adoptées par l'associé unique seront établies par écrit et signées par l'associé unique.
24.3 Les copies ou extraits des résolutions écrites adoptées par les associés, ainsi que les procès-verbaux des assem-
blées générales à produire en justice ou ailleurs sont signés par deux (2) Gérants agissant conjointement.
Titre V. - Exercice social
25. Exercice social.
25.1 L'exercice social de la Société commence le premier jour de janvier et se termine le dernier jour de décembre
chaque année.
25.2 Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis par le Conseil de Gérance et le
Conseil de Gérance prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.
25.3 Chaque associé peut prendre connaissance dudit inventaire et du bilan au siège social de la Société.
26. Distribution des Profits.
26.1 Les profits d'un exercice social, après déduction des frais généraux et opérationnels, des charges et des amor-
tissements, constituent le bénéfice net de la Société pour cette période.
26.2 Le bénéfice net ainsi déterminé, cinq pour cent (5%) sera prélevé pour la constitution de la réserve légale. Ce
prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le montant de la réserve légale aura atteint dix pour cent (10%) du capital
social.
26.3 Dans la mesure où des fonds peuvent être distribués au niveau de la Société tant dans le respect de des Lois que
des Statuts, le Conseil de Gérance pourra proposer que les fonds disponibles soient distribués.
26.4 La décision de distribuer des fonds et d'en déterminer le montant sera prise par l'assemblée générale des associés.
26.5 Des acomptes sur dividendes pourront être distribués par le Conseil de Gérance en conformité avec la loi et à
condition que le Conseil de Gérance ait déjà pris toute mesure nécessaire afin de déterminer l'existence d'un bénéfice
distribuable au sens de la loi.
71313
L
U X E M B O U R G
Titre VI. - Liquidation
27. Liquidation.
27.1 La liquidation de la Société ne peut être décidée qu'en conformité avec les Lois et les dispositions de tout accord
conclu entre la Société et les associés de temps à autre.
27.2 La liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui déter-
mineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Titre VII. - loi applicable
28. Loi applicable. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique des Statuts, il est fait référence aux
Lois.
Titre VIII. - Définitions
29. Définitions. Les termes suivants, lorsqu'ils commencent par une lettre majuscule, auront la signification qui leur
est attribuée dans le présent Article:
Affilié
désigne toute personne morale qui, en relation avec la personne concernée (si celle-
ci est une société), contrôle (directement ou indirectement ) cette personne ou est
contrôlée (directement ou indirectement) par cette personne ou par une société
contrôlant (directement ou indirectement ) cette personne; dans ce contexte
"contrôle" signifie (i) la détention d'une majorité des droits de vote ou du droit
d'exercer la majorité des droits de vote en vertu d'un accord; ou (ii) le droit de
nommer ou d'élire une majorité des membres du conseil d'administration; à
condition que, sauf disposition contraire mentionnée dans tout accord conclu entre
la Société et les associés de temps à autre, la Société ne puisse jamais être considérée
ni comme l'Affilié des Associés de Catégorie A ni comme l'Affilié des Associés de
Catégorie B. Afin d'éviter toute incertitude, un Affilié, au sens ainsi défini, sera
également: (i) une société ou un fonds qui est géré ou conseillé par une société qui
est un Affilié des Associés de Catégorie B ou (ii) une société ou un fonds qui est géré
ou conseillé par une société qui est un Affilié des Associés de Catégorie A.
Affaires Réservées
a la signification énoncée à l'Article 14.17.
Assemblée des Associés
Butendiek
signifie l'assemblée des associés de la Société de Projet.
Associé Commandité
signifie OWP Butendiek Verwaltungs GmbH.
Associé de Catégorie A
signifie le titulaire de Parts Sociales de Catégorie A.
Associé de Catégorie B
signifie le titulaire de Parts Sociales de Catégorie B.
Comité des Investisseurs
Butendiek
signifie un organe social au niveau de la Société de Projet composée de représentants
de ses associés commanditaires.
Conseil de Gérance
a la signification énoncée à l'Article 9.1.
Gérant
a la signification énoncée à l'Article 9.1.
Gérants
a la signification énoncée à l'Article 9.1.
Gérant de Catégorie A
a la signification énoncée à l'Article 9.1.
Gérant de Catégorie B
a la signification énoncée à l'Article 9.1.
Jour Ouvrable
signifie un jour où les banques sont généralement ouvertes au Luxembourg et en
France, sauf pour les besoins de l'Article 14 où ce terme signifie un jour où les
banques sont généralement ouvertes en Allemagne.
Lois
a la signification énoncée à l'Article 1.1.
Membres IC de la Société
signifie deux membres du Comité des Investisseurs Butendiek nommés par la Société.
Participation Butendiek
signifie une participation détenue par la Société dans la Société de Projet sous la
forme d'une participation d'associé commanditaire.
Parts Sociales de Catégorie A
a la signification énoncée à l'Article 5.1.
Parts Sociales de Catégorie B
a la signification énoncée à l'Article 5.1.
Société
a la signification énoncée à l'Article 1.1.
Société de Projet
OWP Butendiek GmbH & Co. KG, un véhicule ad-hoc sous la forme juridique d'une
société en commandite de droit allemand avec une société à responsabilité limitée
de droit allemand comme associé commandité.
Statuts
a la signification énoncée à l'Article 1.1.
»
71314
L
U X E M B O U R G
<i>Deuxième résolutioni>
Les Associés ont décidé de requalifier (i) les vingt-cinq mille (25.000) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale
d'un euro (EUR 1,-) chacune détenues par Marguerite Holdings S.à r.l. en vingt-cinq mille (25.000) parts sociales ordinaires
de catégorie A ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, et (ii) les douze mille cinq cents (12.500) parts
sociales ordinaires ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune détenues par CDC Infrastructure en douze
mille cinq cents (12.500) parts sociales ordinaires de catégorie B ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune.
<i>Troisième résolutioni>
Les Associés ont décidé d'accepter la démission de Nicolas Merigo, gérant et de Michael Dedieu, gérant, avec effet à
compter de la date des présentes.
<i>Quatrième résolutioni>
Les Associés ont décidé de fixer le nombre des gérants à trois (3), dont deux (2) gérants de catégorie A et un (1)
gérant de catégorie B.
<i>Cinquième résolutioni>
Les Associés ont décidé de qualifier les gérants existants, David Harrison et William Pierson, de gérants de catégorie
A de la Société pour une durée illimitée, avec effet à compter de la date des présentes.
<i>Sixième résolutioni>
Les Associés ont décidé de nommer Julien Gailleton, directeur d'investissement chez CDC Infra, né le 26 février 1979
à Tassin-la-Demi-Lune, France, et résidant au 7, avenue Rachel, 75018 Paris, France , en tant que gérant de catégorie B
de la Société pour une durée illimitée, avec effet à compter de la date des présentes.
<i>Septième résolutioni>
Les Associés ont décidé de fixer à un (1) le nombre de commissaires et ont de plus décider de nommer la société
suivante pour une période débutant lors de l'audit des états financiers pour la période se terminant le 31 décembre 2013
et prenant fin lors de l'assemblée générale annuelle des associés approuvant les comptes annuels de l'exercice social se
terminant le 31 décembre 2014:
Artemis Audit & Advisory, une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 25 A, Boulevard Royal, L -
2449 Luxembourg, immatriculé auprès du Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B166716.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges de toute nature qui incombent à la Société en raison du présent acte
sont estimés à environ mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).
Rien d'autre n'étant prévu à ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui connaît et parle la langue anglaise déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-
avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes comparants,
en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Dont acte, passé à Luxembourg par le notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite aux comparants connus du notaire soussigné par leur nom, prénom usuel, état et demeure,
ils ont signé avec, le notaire soussigné, le présent acte.
Signé: Harrison, Dedieu, Vandevoorde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 13 décembre 2013. Relation: EAC/2013/16464. Reçu soixante-quinze euros
75,00€.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Santioni.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2014049945/861.
(140056772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2014.
Gilmour Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 113.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 167.249.
In the year two thousand and fourteen, on the twenty fourth day of March.
Before Us, Maître Léonie GRETHEN, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
was held
71315
L
U X E M B O U R G
an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of Gilmour Holdings S.à r.l., a private limited liability
company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its
registered office at 46a, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the
Luxembourg Register of Commerce and Companies (the RCS) under number B 167249, and having a share capital of one
hundred thirteen thousand five hundred Pounds Sterling (GBP 113,500.-) (the Company). The Company has been incor-
porated on February 17, 2012 pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 946, on April
12, 2012. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended on July 11, 2012 pursuant to a
deed of Maître Henry Hellinckx, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations under number 2475 and 2476, on October 4, 2012.
There appeared:
1. WESTPORT INVESTMENTS S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated
under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 46a, Avenue J.F. Kennedy, L-1855
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the RCS under number B 155231, and having a share capital
of one hundred twenty five thousand Pounds Sterling (GBP 125,000.-),
here represented by Ms Monique Drauth, notary clerk, with professional address in Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on March 24, 2014;
2. FREP Holdings Canada I L.P., a limited partnership established under the laws of Alberta, Canada, having its registered
office at 1100-10830 Jasper Avenue, Edmonton, Alberta, Canada T5J 2B3,
here represented by Ms Monique Drauth, notary clerk, with professional address in Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on March 21, 2014, and
3. LONDAC NO 1 S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 7, Val Sainte-Croix, L-1371 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, registered with the RCS under number B 168146, and having a share capital of twelve thousand
five hundred Euros (EURO 12,500.-),
here represented by Ms Monique Drauth, notary clerk, with professional address in Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on March 24, 2014;
(hereinafter collectively the Shareholders).
The said proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned
notary, shall remain attached to this notarial deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The Shareholders, represented as stated above, have unanimously requested the undersigned notary to record the
following:
<i>First resolutioni>
The Shareholders decide to amend the Art. 17.1 of the Articles which will henceforth read as follows:
“ Art. 17.1.
17.1 The Company shall be managed by a Board comprised of up to seven (7) Managers who need not be Shareholders,
as follows:
(a) up to two (2) Sub-Class 2 Managers appointed in accordance with Articles 17.2 below and 17.6 below, both of
whom (while the Company shall be tax resident in Luxembourg) shall at all times be Resident Managers;
(b) up to two (2) Sub-Class 1 Managers appointed in accordance with Articles 17.3 and 17.6 below, of which (while
the Company shall be tax resident in Luxembourg) at least one (1) shall at all times be a Resident Manager; and
(c) up to three (3) Sub-Class 3 Managers appointed in accordance with Articles 17.4 and 17.6 below, of which (while
the Company shall be tax resident in Luxembourg) at least one (1) shall at all times be a Resident Manager”.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are
estimated at one thousand Euro (EUR 1,000.-).
There being no other business on the agenda, the meeting was closed.
The undersigned notary who knows and speaks English, states herewith that on request of the above appearing persons,
the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of
divergences between the English and the French text, the English text will prevail.
Whereupon, the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the
beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing persons, who is known to the undersigned notary
by his surname, first name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original
deed.
71316
L
U X E M B O U R G
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quatorze, le vingt-quatre mars.
Pardevant Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est tenue
une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de Gilmour Holdings S.à r.l., une société à respon-
sabilité limitée organisée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, avec siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg (le «RCS») sous le numéro B 167249 et ayant un capital social de cent treize mille cinq cents Livres Sterling (GBP
113.500,-) (la «Société»). La Société a été constituée le 17 février 2012 suivant un acte de Maître Martine Schaeffer,
notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Asso-
ciations sous le numero 946 du 12 avril 2012. Les statuts de la Société (les «Statuts») ont été modifiés le 11 juillet 2012
suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au
Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations sous les numéros 2475 et 2476 du 4 octobre 2012.
A comparu:
1. WESTPORT INVESTMENTS S.à r.l., une société à responsabilité limitée, organisée selon les lois du Grand-Duché
de Luxembourg, avec siège social au 46a, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
immatriculée au RCS sous le numéro B 155231 et ayant un capital social de cent vingt-cinq mille Livres Sterling (GBP
125.000,-),
ici représentée par Mme Monique Drauth, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 24 mars 2014;
2. FREP Holdings Canada I L.P., une société en commandite établie selon le droit d'Alberta, Canada, ayant son siège
social au 110-10830 Jasper Avenue Edmonton, Alberta, Canada T5J 2B3,
ici représentée par Mme Monique Drauth, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 21 mars 2014, et
3. LONDAC NO 1 S.à r.l., une société à responsabilité limitée, organisée selon les lois du Grand-Duché de Luxem-
bourg, avec siège social au 7, Val Sainte-Croix, L-1371 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au RCS
sous le numéro B 168146 et ayant un capital social de douze mille cinq cents Euros (EURO 12.500,-),
ici représentée par Mme Monique Drauth, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 24 mars 2014,
(ci-après collectivement les “Associés”).
Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par la mandataire des parties comparantes, ainsi que par le
notaire soussigné, resteront annexées au présent acte notarié pour être soumises ensemble aux formalités d'enregistre-
ment.
Les Associés, représentés comme dit ci-avant, ont unanimement requis le notaire soussigné d'acter ce qui suit:
<i>Première résolutioni>
Les Associé ont décidé de modifier l'art. 17.1 qui devra être lu comme suit:
Art. 17.1.
«17.1 La Société est administrée par un conseil composé de sept (7) Gérant(s) maximum qui n'a (ont) pas besoin d'être
Associés, comme suit:
(a) jusqu'à deux (2) Gérants de Sous-Classe 2 nommés en accord avec les Articles 17.2 et 17.6 ci-dessous, qui seront
tous deux (pendant que la Société est résidante à Luxembourg) des Gérants Résidants;
(b) jusqu'à deux (2) Gérants de Sous-Classe 1 nommés en accord avec les Articles 17.3 et 17.6 ci-dessous, et un (1)
d'entre eux (pendant que la Société est résidante à Luxembourg) au moins sera un Gérant Résidant; et
(c) jusqu'à trois (3) Gérants de Sous-Classe 3 nommés en accord avec les Articles 17.4 et 17.6 ci-dessous, et un (1)
d'entre eux (pendant que la Société est résidante à Luxembourg) au moins sera un Gérant Résidant.».
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de cet acte sont
estimés à environ mille euros (EUR 1.000,-).
N'étant plus d'autres points à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui connaît et parle la langue anglaise, a déclaré par la présente qu'à la demande des comparants,
le présent acte a été rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; à la demande des mêmes comparants et en
cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
71317
L
U X E M B O U R G
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée à la mandataire des comparants connue du notaire soussigné
par ses nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec le notaire soussigné, le présent acte.
Signé: Drauth, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 26 mars 2014. Relation: LAC/2014/14063. Reçu soixante-quinze euros (75,00
€)
<i>Le Receveuri> (signé): Irène Thill.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Luxembourg, le 4 avril 2014.
Référence de publication: 2014049787/127.
(140056448) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2014.
Capula Luxembourg Limited, Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 200.000,00.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 160.145.
In the year two thousand and fourteen, on the eighteenth day of March;
Before us Maître Edouard Delosch, notary residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg;
Was held
an extraordinary general meeting of the shareholders of Capula Luxembourg Limited, a Luxembourg private limited
liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 5, avenue Gaston Diderich, L-1420
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under num-
ber B 160.145, having a share capital of one hundred sixty thousand United States dollars (USD 160,000) and incorporated
pursuant to the laws of the Grand Duchy of Luxembourg pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing
in Luxembourg, on 25 March 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 15 July 2011,
number 1588 (the "Company"). The articles of association have been amended for the last time pursuant to a deed of
the undersigned notary, on 13 March 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 15 May
2013, number 1144.
The present meeting was opened at 6.00 p.m., with Victorien Hémery, Avocat à la Cour, professionally residing in
Luxembourg, in the chair, who appointed as secretary Amaury Lambert, Avocat, residing in Luxembourg (the “Meeting”).
The Meeting elected as scrutineer Codrina Constantinescu, Avocat, residing in Luxembourg.
The board of the Meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
That the shareholders represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are
shown on an attendance list; this attendance list, signed by the proxies of the represented shareholders and by the board
of the meeting, will remain annexed to this deed to be filed at the same time with the registration authorities. The proxies
of the represented shareholders, initialed “ne varietur” by the appearing parties will also remain annexed to this deed;
That four million (4,000,000) Class A, eight million (8,000,000) Class B, two million Class C (2,000,000) and two million
(2,000,000) Class D shares of the Company representing the entire share capital of the Company are represented at the
Meeting and so that the Meeting can validly decide on all the items of the agenda which are known to the shareholders;
That the agenda of the Meeting is worded as follows:
Waiver of the convening formalities;
Increase of the share capital of the Company by an amount of forty thousand United States dollars (USD 40,000), so
as to raise it from its present amount of one hundred sixty thousand United States dollars (USD 160,000) up to two
hundred thousand United States dollars (USD 200,000) by the issue of four million (4,000,000) class E shares of series 1
to 9, each having a par value of one United States cent (USD 0,01);
Amendment of article 5.1 of the articles of association of the Company.
<i>First resolutioni>
The Meeting resolves to waive all convening notices requirements and procedures in relation to the present meeting.
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of forty thousand United States
dollars (USD 40,000), so as to raise it from its present amount of one hundred sixty thousand United States dollars (USD
160,000) up to two hundred thousand United States dollars (USD 200,000) by the issue of four million (4,000,000) class
E shares of series 1 to 9.
The new class E shares are subscribed as follows:
71318
L
U X E M B O U R G
Two million two hundred thirty-six thousand three hundred fifty-eight (2,236,358) Class E shares series 1 are sub-
scribed by Yan Huo, born on 4 December 1968 in China, residing professionally at 8 Lancelot Place, London, SW7 1DR,
United Kingdom, duly represented by Victorien Hémery, Avocat à la Cour, having his professional address in Luxembourg
City, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given on 13 February 2014 in London, paid up by a contribution
in cash of twenty-two thousand three hundred sixty-three United States dollars and fifty-eight cents (USD 22,363.58),
entirely allocated to the share capital of the Company; and
Two hundred fifty-three thousand forty-seven (253,047) Class E shares series 2 are subscribed by Masao Asai, born
on 20 August 1966 in Aichi, residing professionally at 8 Lancelot Place, London, SW7 1DR, United Kingdom, duly repre-
sented by Victorien Hémery, Avocat à la Cour, having his professional address in Luxembourg City, Grand Duchy of
Luxembourg, by virtue of a proxy given on 13 February 2014 in London, paid up by a contribution in cash of two thousand
five hundred thirty United States dollars and forty-seven cents (USD 2,530.47), entirely allocated to the share capital of
the Company; and
Five hundred one thousand one hundred fifty-five (501,155) Class E shares series 3 are subscribed by Piyush Bharti,
born on 27 September 1976 in Michigan, residing professionally at 55 Railroad Avenue, Greenwich, CT 06830, United
States of America, duly represented by Victorien Hémery, Avocat à la Cour, having his professional address in Luxembourg
City, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given on 14 February 2014 in Greenwich CT, paid up by a
contribution in cash of five thousand eleven United States dollars and fifty-five cents (USD 5,011.55), entirely allocated
to the share capital of the Company; and
Five hundred seventy-two thousand nine hundred sixty-five (572,965) Class E shares series 4 are subscribed by Bing-
Le Wu, born on 15 July 1962 in China, residing professionally at 8 Lancelot Place, London, SW7 1DR, United Kingdom,
duly represented by Victorien Hémery, Avocat à la Cour, having his professional address in Luxembourg City, Grand
Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given on 13 February 2014 in London, paid up by a contribution in cash of
five thousand seven hundred twenty-nine United States dollars and sixty-five cents (USD 5,729.65), entirely allocated to
the share capital of the Company; and
Fifty-four thousand eight hundred seven (54,807) Class E shares series 5 are subscribed by Sam Xun-Wei Lowe, born
on 21 May 1965 in China, residing professionally at 8 Lancelot Place, London, SW7 1DR, United Kingdom, duly repre-
sented by Victorien Hémery, Avocat à la Cour, having his professional address in Luxembourg City, Grand Duchy of
Luxembourg, by virtue of a proxy given on 18 February 2014 in London, paid up by a contribution in cash of five hundred
forty-eight United States dollars and seven cents (USD 548.07), entirely allocated to the share capital of the Company;
and
Fifty-one thousand two hundred fifty-five (51,255) Class E shares series 6 are subscribed by Thorkild Peter Juncker,
born on 25 March 1956 in Arhus, residing professionally at 8 Lancelot Place, London, SW7 1DR, United Kingdom, duly
represented by Victorien Hémery, Avocat à la Cour, having his professional address in Luxembourg City, Grand Duchy
of Luxembourg, by virtue of a proxy given on 13 February 2014 in London, paid up by a contribution in cash of five
hundred twelve United States dollars and fifty-five cents (USD 512.55), entirely allocated to the share capital of the
Company; and
Twenty-two thousand and eighty-three (22,083) Class E shares series 7 are subscribed by David Gu, born on 3 De-
cember 1962 in Suzhou, China, residing professionally at 8 Lancelot Place, London, SW7 1DR, United Kingdom, duly
represented by Victorien Hémery, Avocat à la Cour, having his professional address in Luxembourg City, Grand Duchy
of Luxembourg, by virtue of a proxy given on 14 February 2014 in London, paid up by a contribution in cash of two
hundred twenty United States dollars and eighty-three cents (USD 220.83), entirely allocated to the share capital of the
Company; and
Forty-five thousand five hundred ninety-one (45,591) Class E shares series 8 are subscribed by Steven Alan Gregornik,
born on 24 February 1966 in Illinois, United States of America, residing professionally at 8 Lancelot Place, London, SW7
1DR, United Kingdom, duly represented by Victorien Hémery, Avocat à la Cour, having his professional address in
Luxembourg City, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given on 13 February 2014 in London, paid up by
a contribution in cash of four hundred fifty-five United States dollars and ninety-one cents (USD 455.91), entirely allocated
to the share capital of the Company; and
Two hundred sixty-two thousand seven hundred thirty-nine (262,739) Class E shares series 9 are subscribed by Vincent
Yeung, born on 4 December 1968 in China, residing professionally at 9 Wycombe Square, London, W8 7JD, United
Kingdom, duly represented by Victorien Hémery, Avocat à la Cour, having his professional address in Luxembourg City,
Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given on 13 February 2014 in London, paid up by a contribution in
cash of two thousand six hundred twenty-seven United States dollars and thirty-nine cents (USD 2,627.39), entirely
allocated to the share capital of the Company; and
The proof of the existence and of the value of the above contributions has been produced to the undersigned notary.
Now being shareholders of the Company the new shareholder Vincent Yeung duly represented by Victorien Hémery,
Avocat à la Cour, as described above join the present meeting.
Four million (4,000,000) class A shares of the Company, eight million (8,000,000) class B shares of the Company, two
million (2,000,000) class C shares of the Company, two million (2,000,000) class D shares of the Company and four million
71319
L
U X E M B O U R G
(4,000,000) class E shares of the Company representing the entire share capital of the Company are now represented at
the present meeting and so the Meeting can validly decide on the following item of the agenda:
<i>Third resolutioni>
The Meeting resolves to amend article 5.1 of the articles of the association of the Company which shall now read as
follows:
“ Art. 5. Share Capital. The Company's share capital is fixed at two hundred thousand United States dollars (USD
200,000), represented by:
Two million one hundred eighty-one thousand eight hundred and seventy five (2,181,875) class A shares, series 1 and
five million seven hundred thirteen thousand eight hundred and fourteen (5,713,814) class B shares, series 1 and one
hundred thirty-one thousand six hundred ninety-five (131,695) class C shares, series 1 and one million one hundred five
thousand six hundred ninety-four (1,105,694) class D shares, series 1 and two million two hundred thirty-six thousand
three hundred fifty-eight (2,236,358) class E shares, series 1;
Two hundred sixty-eight thousand two hundred and sixty-four (268,264) class A shares, series 2 and five hundred
forty-four thousand one hundred and fifty-four (544,154) class B shares, series 2 and one hundred two thousand eight
hundred (102,800) class C shares, series 2 and three hundred thirty-eight thousand seven hundred one (338,701) class
D shares, series 2, and two hundred fifty-three thousand forty-seven (253,047) class E shares, series 2;
Ninety-six thousand four hundred and eighteen (96,418) class A shares, series 3 and one hundred ninety-four thousand
five hundred and twenty-five (194,525) class B shares, series 3 and one hundred twenty-seven thousand seventy-nine
(127,079) class C shares, series 3 and sixty-two thousand nine hundred fifty-six (62,956) class D shares, series 3 and five
hundred one thousand one hundred fifty-five (501,155) class E shares, series 3;
Fifty-two thousand nine hundred and seventy-one (52,971) class A shares, series 4 and eighty-seven thousand nine
hundred and eighty-nine (87,989) class B shares, series 4 and two hundred ten thousand six hundred fifty-three (210,653)
class C shares, series 4 and twelve thousand five hundred ninety-one (12,591) class D shares, series 4, and five hundred
seventy-two thousand nine hundred sixty-five (572,965) class E shares, series 4;
Eighty one thousand five hundred and seventy (81,570) class A shares, series 5 and forty-nine thousand six hundred
and ninety-six (49,696) class B shares, series 5 and six hundred fifty-three thousand seven hundred thirty-four (653,734)
class C shares, series 5 and thirty-seven thousand seven hundred seventy-four (37,774) class D shares, series 5 and fifty-
four thousand eight hundred seven (54,807) class E shares, series 5;
Eighty-four thousand six hundred and twenty-five (84,625) class A shares, series 6 and one hundred sixty-five thousand
eight hundred and forty-one (165,841) class B shares, series 6 and seventy-two thousand eight hundred forty-nine (72,849)
class C shares, series 6 and one hundred twenty-five thousand nine hundred twelve (125,912) class D shares, series 6
and fifty-one thousand two hundred fifty-five (51,255) class E shares, series 6;
Two hundred sixty thousand two hundred and eighty-one (260,281) class A shares, series 7 and four hundred twenty-
four thousand eight hundred and thirty-one (424,831) class B shares, series 7 and one hundred thirty-five thousand nine
hundred ninety-eight (135,998) class C shares, series 7 and twelve thousand five hundred ninety-one (12,591) shares class
D, series 7 and twenty-two thousand and eighty-three (22,083) class E shares, series 7;
Seven hundred ninety thousand eight hundred and ninety-four (790,894) class A shares, series 8 and three hundred
thirty thousand nine hundred and fifteen (330,915) class B shares, series 8 and eighty-three thousand nine hundred six
(83,906) class C shares, series 8 and twelve thousand five hundred ninety-one (12,591) class D shares, series 8 and forty-
five thousand five hundred ninety-one (45,591) class E shares, series 8;
Thirty-four thousand three hundred and nineteen (34,319) class A shares, series 9 and fifty-eight thousand one hundred
and thirty-five (58,135) class B shares, series 9 and seventy-nine thousand seven hundred forty-one (79,741) class C shares,
series 9 and twelve thousand five hundred ninety-one (12,591) class D shares, series 9 and two hundred sixty-two
thousand seven hundred thirty-nine (262,739) class E shares, series 9;
Sixty-nine thousand two hundred and seventy-three (69,273) class A shares, series 10 and one hundred sixty-nine
thousand seven hundred and eighty-nine (169,789) class B shares, series 10 and one hundred eighty-eight thousand seven
hundred ninety (188,790) class C shares, series 10 and one hundred twenty-six thousand five hundred eleven (126,511)
class D shares, series 10;
Seventy-nine thousand five hundred and ten (79,510) class A shares, series 11 and one hundred twenty-nine thousand
seven hundred and fifty-three (129,753) class B shares, series 11 and two hundred twelve thousand seven hundred and
fifty-five (212,755) class C shares, series 11 and fifty thousand three hundred sixty-five (50,365) class D shares, series 11;
Ninety-eight thousand six hundred and seventy-four (98,674) class B shares, series 12 and twelve thousand five hundred
ninety-one (12,591) class D shares, series 12;
Thirty-one thousand eight hundred and eighty-four (31,884) class B shares, series 13 and eighty-nine thousand one
hundred thirty-two (89,132) class D shares, series 13
each share having a par value of one United States cent (USD 0.01).”
Nothing else being on the agenda. The meeting was closed at 6.15 p.m.
71320
L
U X E M B O U R G
<i>Estimated costsi>
The aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which are to be
borne by the Company or which shall be charged to the Company by reason of this deed, are estimated at approximately
one thousand three hundred euros (EUR 1,300).
<i>Declarationi>
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The undersigned notary, who knows and understands English, states that on request of the appearing party, the present
deed is worded in English, followed by a German version and in case of discrepancies between the English and the German
texts, the English version will be binding.
The document having been read to the person appearing, said person appearing, signed together with the notary the
present original deed.
Deutsche Uebersetzung des vorstehenden Textes
Vor uns Maître Edouard Delosch, Notar mit Amtssitz in Diekirch, Großherzogtum Luxemburg;
Wurde eine
außerordentliche Gesellschafterversammlung der Gesellschaft Capula Luxembourg Limited, eine luxemburgische Ge-
sellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), mit Gesellschaftssitz in 5, avenue Gaston Diderich,
L-1420 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg eingetragen im luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister
unter Nummer B 160145, gegründet nach dem Recht Luxemburgs durch die Urkunde von Maître Martine Schaeffer,
Notarin mit Amtssitz in Luxemburg vom 25. März 2011, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
N°1588 am 15. Juli 2011 (die “Gesellschaft”) abgehalten. Die Satzung der Gesellschaft wurde abgeändert zufolge Urkunde
aufgenommen durch den handelnden Notar, am 13. März 2013, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations N°1144 am 15. Mai 2013.
Die Versammlung wurde um 18.00, durch Victorien Hémery, Avocat à la Cour, mit Geschäftsadresse in Luxemburg,
als Vorsitzender eröffnet, welcher Amaury Lambert, Avocat, mit Geschäftsadresse in Luxemburg, als Sekretär ernannt
hat (die „Versammlung“).
Die Versammlung wählte als Stimmenzählerin Codrina Constantinescu, Avocat, mit Geschäftsadresse in Luxemburg.
Die Versammlungsleitung, die sich somit konstituiert hatte, erklärte und beantragte durch den Vorsitzenden, den Notar
folgendes zu beurkunden:
Dass die vertretenen Gesellschafter, die Bevollmächtigten der vertretenen Gesellschafter und die Anzahl der gehalt-
enen Geschäftsanteile sich aus der Anwesenheitsliste ergeben. Diese Anwesenheitsliste, unterzeichnet durch die Bevoll-
mächtigen der vertretenen Gesellschafter und durch die Versammlungsleitung, bleibt diesem notariellen Akt beigefügt
und wird mit diesem bei der Registrierungsbehörde eingereicht. Die Vollmachten der vertretenen Gesellschafter, unter-
zeichnet „ne varietur“, durch die erschienen Parteien, werden ebenfalls diesem notariellen Akt beigefügt;
Dass vier Millionen (4.000.000) Klasse A Geschäftsanteile der Gesellschaft acht Millionen (8.000.000) Klasse B Ge-
schäftsanteile der Gesellschaft, zwei Millionen (2.000.000) Klasse C Geschäftsanteile der Gesellschaft und zwei Millionen
(2.000.000) Klasse D Geschäftsanteile der Gesellschaft , welche das gesamte Gesellschaftskapital darstellen, auf dieser
Versammlung vertreten sind, so dass die Versammlung wirksam über alle Punkte der Tagungsordnung, welche den Ge-
sellschaftern bekannt sind, entscheiden kann;
Dass die Tagungsordnung der Versammlung wie folgt lautet:
Verzicht auf die Einberufungsmitteilung;
Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft um einen Betrag von vierzigtausend US Dollar (USD 40.000), um es so
von seinem derzeitigen Betrag von einhundertsechzigtausend US Dollar (USD 160.000), auf zweihunderttausend US Dol-
lar (USD 200.000) anzuheben, durch die Ausgabe von vier Millionen (4.000.000) Klasse E Geschäftsanteilen, der Serien 1
bis 9, welche jeweils einen Nennwert von einem US Cent (USD 0,01) haben;
Abänderung von Artikel 5.1 der Satzung der Gesellschaft.
<i>Erster Beschlussi>
Die Versammlung beschließt, auf die Voraussetzungen und das Verfahren der Einberufungsmitteilung in Bezug auf diese
Versammlung zu verzichten.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Versammlung beschließt, das Stammkapital der Gesellschaft um einen Betrag von vierzigtausend US Dollar (USD
40.000), zu erhöhen, um es so von seinem derzeitigen Betrag von einhundertsechzigtausend US Dollar (USD 160.000),
auf zweihunderttausend US Dollar (USD 200.000) anzuheben, durch die Ausgabe von vier Millionen (4.000.000) Klasse
E Geschäftsanteilen, der Serien 1 bis 9, welche jeweils einen Nennwert von einem US Cent (USD 0,01) haben;
Die neuen Klasse E Geschäftsanteile werden wie folgt gezeichnet:
71321
L
U X E M B O U R G
Zwei Millionen zweihundertsechsunddreißigdreihundertachtundfünfzig (2.236.358) Klasse E Geschäftsanteile der Serie
1 werden gezeichnet durch Yan Huo, geboren am 4. Dezember 1968 in China, mit Geschäftsadresse in 8 Lancelot Place,
London, SW7 1DR, Vereinigte Königreich, hier vertreten durch Victorien Hémery, Avocat à la Cour,, mit Geschäftsad-
resse in Luxemburg, Groâherzogtum Luxemburg, kraft einer am 13. Februar 2014 in London erteilten Vollmacht, gezahlt
durch Einlage in bar von zweiundzwanzigtausenddreihundertdreiundsechzig US Dollar und achtundfünfzig Cents (USD
22.363,58), welche vollständig dem Stammkapital der Gesellschaft zugewiesen werden.
Zweihundertdreiundfünfzigtausendsiebenundvierzig (253.047) Klasse E Geschäftsanteile der Serie 2 werden gezeichnet
durch Masao Asai, geboren am 20. August 1966 in Aichi, mit Geschäftsadresse in 8 Lancelot Place, London, SW7 1DR,
Vereinigte Königreich, hier vertreten durch Victorien Hémery, Avocat à la Cour, mit Geschäftsadresse in Luxemburg,
Groâherzogtum Luxemburg, kraft einer am 13. Februar 2014 in London erteilten Vollmacht, gezahlt durch die Einlage in
bar von zweitausendfünfhundertdreißig US Dollar und siebenundvierzig Cents (USD 2.530,47), welche vollständig dem
Stammkapital der Gesellschaft zugewiesen werden.
Fünfhunderteintausendeinhundertfünfundfünfzig (501.155) Klasse E Geschäftsanteile der Serie 3 werden gezeichnet
durch Piyush Bharti, geboren am 27. September 1976 in Michigan, mit Geschäftsadresse in 55 Railroad Avenue, Greenwich,
CT 06830, Vereinigte Staaten von Amerika, hier vertreten durch Victorien Hémery, Avocat à la Cour, mit Geschäftsad-
resse in Luxemburg, Groâherzogtum Luxemburg, kraft einer am 14. Februar 2014 in Greenwich CT erteilten Vollmacht,
gezahlt durch die Einlage in bar von fünftausendelf US Dollar und fünfundfünfzig Cents (USD 5.011,55), welche vollständig
dem Stammkapital der Gesellschaft zugewiesen werden.
Fünfhundertzweiundsiebzigtausendneunhundertfünfundsechzig (572.965) Klasse E Geschäftsanteile der Serie 4 werden
gezeichnet durch Bing-Le Wu, geboren am 15. Juli 1962 in China, mit Geschäftsadresse in 8 Lancelot Place, London, SW7
1DR, Vereinigte Königreich, hier vertreten durch Victorien Hémery, Avocat à la Cour, mit Geschäftsadresse in Luxem-
burg, Groâherzogtum Luxemburg, kraft einer am 13. Februar 2014 in London erteilten Vollmacht, gezahlt durch die
Einlage in bar von fünftausendsiebenhundertneunundzwanzig US Dollar und fünfundsechzig Cents (USD 5.729,65), welche
vollständig dem Stammkapital der Gesellschaft zugewiesen werden.
Vierundfünfzigtausendachthundertsieben (54.807) Klasse E Geschäftsanteile der Serie 5 werden gezeichnet durch Sam
Xun-Wei Lowe, geboren am 21. Mai 1965 in China, mit Geschäftsadresse in 8 Lancelot Place, London, SW7 1DR, Ver-
einigte Königreich, hier vertreten durch Victorien Hémery, Avocat à la Cour, mit Geschäftsadresse in Luxemburg,
Groâherzogtum Luxemburg, kraft einer am 18. Februar 2014 in London erteilten Vollmacht, gezahlt durch die Einlage in
bar von fünfhundertachtundvierzig US Dollar und sieben Cents (USD 548,07), welche vollständig dem Stammkapital der
Gesellschaft zugewiesen werden.
Einundfünfzigtausendzweihundertfünfundfünfzig (51.255) Klasse E Geschäftsanteile der Serie 6 werden gezeichnet
durch Thorkild Peter Juncker, geboren am 25. März 1956 in Arhus, mit Geschäftsadresse in 8 Lancelot Place, London,
SW7 1DR, Vereinigte Königreich, hier vertreten durch Victorien Hémery, Avocat à la Cour, mit Geschäftsadresse in
Luxemburg, Groâherzogtum Luxemburg, kraft einer am 13. Februar 2014 in London erteilten Vollmacht, gezahlt durch
die Einlage in bar von fünfhundertzwölf US Dollar und fünfundfünfzig Cents (USD 512,55), welche vollständig dem
Stammkapital der Gesellschaft zugewiesen werden.
Zweiundzwanzigtausenddreiundachtzig (22.083) Klasse E Geschäftsanteile der Serie 7 werden gezeichnet durch David
Gu, geboren am 3. Dezember 1962 in Suzhou, China, mit Geschäftsadresse in 8 Lancelot Place, London, SW7 1DR,
Vereinigte Königreich, hier vertreten durch Victorien Hémery, Avocat à la Cour, mit Geschäftsadresse in Luxemburg,
Groâherzogtum Luxemburg, kraft einer am 14. Februar 2014 in London erteilten Vollmacht, gezahlt durch die Einlage in
bar von zweihundertzwanzig US Dollar und dreiundachtzig Cents (USD 222,83), welche vollständig dem Stammkapital
der Gesellschaft zugewiesen werden.
Fünfundvierzigtausendfünfhunderteinundneunzig (45.591) Klasse E Geschäftsanteile der Serie 8 werden gezeichnet
durch Steven Alan Gregornik, geboren am 26. Februar 1966 in Illinois, Vereinigte Staaten von Amerika, mit Geschäfts-
adresse in 8 Lancelot Place, London, SW7 1DR, Vereinigte Königreich, hier vertreten durch Victorien Hémery, Avocat
à la Cour, mit Geschäftsadresse in Luxemburg, Groâherzogtum Luxemburg, kraft einer am 13. Februar 2014 in London
erteilten Vollmacht, gezahlt durch die Einlage in bar von vierhundertfünfundfünfzig US Dollar und einundneunzig Cents
(USD 455,91), welche vollständig dem Stammkapital der Gesellschaft zugewiesen werden.
Zweihundertzweiundsechzigtausendsiebenhundertneununddreißig (262.739) Klasse E Geschäftsanteile der Serie 9
werden gezeichnet durch Vincent Yeung, geboren am 4. Dezember 1968 in China, mit Geschäftsadresse in 9 Wycombe
Square, London, W8 7JD, Vereinigte Königreich, hier vertreten durch Victorien Hémery, Avocat à la Cour, mit Ge-
schäftsadresse in Luxemburg, Groâherzogtum Luxemburg, kraft einer am 13. Februar 2014 in London erteilten Vollmacht,
gezahlt durch die Einlage in bar von zweitausendsechshundertsiebenundzwanzig US Dollar und neununddreißig Cents
(USD 2.627,39), welche vollständig dem Stammkapital der Gesellschaft zugewiesen werden.
Der Beweis über das Bestehen und den Wert der obigen Einlagen wurde dem unterzeichnenden Notar vorgelegt.
Jetzt, da sie Gesellschafter der Gesellschaft sind, erscheint der neue Gesellschafter Vincent Yeung vetreten durch
Victorien Hémery, Avocat à la Cour wie oben beschrieben.
Vier Million (4.000.000) Klasse A Geschäftsanteile und acht Millionen (8.000.000) Klasse B Geschäftsanteile und zwei
Millionen (2.000.000) Klasse C Geschäftsanteile, zwei Millionen (2.000.000) Klasse D Geschäftsanteile und vier Millionen
71322
L
U X E M B O U R G
(4.000.000) Klasse E Geschäftsanteile, welche das gesamte Gesellschaftskapital der Gesellschaft darstellen, auf dieser
Versammlung vertreten sind, kann die Versammlung wirksam über die folgenden Punkte der Tagungsordnung entscheiden:
<i>Dritter Beschlussi>
Die Versammlung beschließt Artikel 5.1 der Satzung der Gesellschaft zu ändern, welcher nunmehr wie folgt lautet:
„ Art. 5. Stammkapital.
5.1 Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zweihunderttausend US Dollar (USD 200.000) bestehend aus:
Zwei Millionen einhunderteinundachtzigtausendachthundertfünfundsiebzig (2.181.875) Klasse A Geschäftsanteile Serie
1 und fünf Millionen siebenhundertdreizehntausendachthundertvierzehn (5.713.814) Klasse B Geschäftsanteile Serie 1
und einhunderteinunddreißigtausendsechshundertfünfundneunzig (131.695) Klasse C Geschäftsanteile Serie 1 und eine
Million einhundertfünftausendsechshundertvierundneunzig (1.105.694) Klasse D Geschäftsanteile Serie 1 und zwei Milli-
onen zweihundertsechsunddreißigdreihundertachtundfünfzig (2.236.358) Klasse E Geschäftsanteile Serie 1;
Zweihundertachtundsechzigtausendzweihundertvierundsechzig (268.264) Klasse A Geschäftsanteile Serie 2 und fünf-
hundertvierundvierzigtausendeinhundertvierundfünfzig (544.154) Klasse B Geschäftsanteile Serie 2 und einhundertzwei-
tausendachthundert (102.800) Klasse C Geschäftsanteile Serie 2 und dreihundertachtunddreißigtausendsiebenhundert-
eins (338.701) Klasse D Geschäftsanteile Serie 2 und zweihundertdreiundfünfzigtausendsiebenundvierzig (253.047) Klasse
E Geschäftsanteile Serie 2;
Sechsundneunzigtausendvierhundertachtzehn (96.418) Klasse A Geschäftsanteile Serie 3 und einhundertvierundneun-
zigtausendfünfhundertfünfundzwanzig (194.525) Klasse B Geschäftsanteile Serie 3 und einhundertsiebenundzwanzigtau-
sendneunundsiebzig (127.079) Klasse C Geschäftsanteile Serie 3 und zweiundsechzigtausendneunhundertsechsundfünfzig
(62.956) Klasse D Geschäftsanteile Serie 3 und fünfhunderteintausendeinhundertfünfundfünfzig (501.155) Klasse E Ge-
schäftsanteile Serie 3;
Zweiundfünfzigtausendneunhunderteinundsiebzig (52.971) Klasse A Geschäftsanteile Serie 4 und siebenundachtzig-
tausendneunhundertneunundachtzig (87.989) Klasse B Geschäftsanteile Serie 4 und zweihundertzehntausendsechshun-
dertdreiundfünfzig (210.653) Klasse C Geschäftsanteile Serie 4 und zwölftausendfünfhunderteinundneunzig (12.591)
Klasse D Geschäftsanteile Serie 4 und fünfhundertzweiundsiebzigtausendneunhundertfünfundsechzig (572.965) Klasse E
Geschäftsanteile Serie 4
Einundachtzigtausendfünfhundertsiebzig (81.570) Klasse A Geschäftsanteile Serie 5 und neunundvierzigtausendsechs-
hundertsechsundneunzig (49.696) Klasse B Geschäftsanteile Serie 5 und sechshundertdreiundfünfzigtausendsiebenhun-
dertvierunddreißig (653.734) Klasse C Geschäftsanteile Serie 5 und siebenunddreißigtausendsiebenhundertvierundsiebzig
(37.774) Klasse D Geschäftsanteile Serie 5 und vierundfünfzigtausendachthundertsieben (54.807) Klasse E Geschäftsan-
teile Serie 5;
Vierundachtzigtausendsechshundertfünfundzwanzig (84.625) Klasse A Geschäftsanteile Serie 6 und einhundertfün-
fundsechzigtausendachthunderteinundvierzig (165.841) Klasse B Geschäftsanteile Serie 6 und zweiundsiebzigtausendach-
thundertneunundvierzig (72.849) Klasse C Geschäftsanteile Serie 6 und einhundertfünfundzwanzigtausendneunhundertz-
wölf (125.912) Klasse D Geschäftsanteile Serie 6 und einundfünfzigtausendzweihundertfünfundfünfzig (51.255) Klasse E
Geschäftsanteile Serie 6;
Zweihundertsechzigtausendzweihunderteinundachtzig (260.281) Klasse A Geschäftsanteile Serie 7 und vierhundert-
vierundzwanzigtausendachthunderteinunddreißig (424.831) Klasse B Geschäftsanteile Serie 7 und einhundertfünfundd-
reißigtausendneunhundertachtundneunzig (135.998) Klasse C Geschäftsanteile Serie 7 und zwölftausendfünfhundertei-
nundneunzig (12.591) Klasse D Geschäftsanteile Serie 7 und zweiundzwanzigtausenddreiundachtzig (22.083) Klasse E
Geschäftsanteile Serie 7;
Siebenhundertneunzigtausendachthundertvierundneunzig (790.894) Klasse A Geschäftsanteile Serie 8 und dreihun-
dertdreißigtausendneunhundertfünfzehn (330.915) Klasse B Geschäftsanteile Serie 8 und dreiundachtzigtausendneunhun-
dertsechs (83.906) Klasse C Geschäftsanteile Serie 8 und zwölftausendfünfhunderteinundneunzig (12.591) Klasse D
Geschäftsanteile Serie 8 und fünfundvierzigtausendfünfhunderteinundneunzig (45.591) Klasse E Geschäftsanteile Serie 8;
Vierunddreiâigtausenddreihundertneunzehn (34.319) Klasse A Geschäftsanteile Serie 9 und achtundfünfzigtausendein-
hunderfünfunddreißig (58.135) Klasse B Geschäftsanteile Serie 9 und neunundsiebzigtausendsiebenhunderteinundvierzig
(79.741) Klasse C Geschäftsanteile Serie 9 und zwölftausendfünfhunderteinundneunzig (12.591) Klasse D Geschäftsanteile
Serie 9 und zweihundertzweiundsechzigtausendsiebenhundertneununddreißig (262.739) Klasse E Geschäftsanteile Serie
9;
Neunundsechzigtausendzweihundertdreiundsiebzig (69.273) Klasse A Geschäftsanteile Serie 10 und einhundertneu-
nundsechzigtausendsiebenhundertneunundachtzig (169.789) Klasse B Geschäftsanteile Serie 10 und einhundertachtun-
dachzigtausendsiebenhundertneunzig (188.790) Klasse C Geschäftsanteile Serie 10 und einhundertsechsundzwanzigtau-
sendfünfhundertelf (126.511) Klasse D Geschäftsanteile Serie 10;
Neunundsiebzigtausendfünfhundertzehn (79.510) Klasse A Geschäftsanteile Serie 11 und einhundertneunundzwanzig-
tausendsiebenhundertdreiundfünfzig (129,753) Klasse B Geschäftsanteile Serie 11 und zweihundertzwölftausendsieben-
hundertfünfundfünfzig (212.755) Klasse C Geschäftsanteile Serie 11 und fünfzigtausenddreihundertfünfundsechzig (50.365)
Klasse D Geschäftsanteile Serie 11,
71323
L
U X E M B O U R G
Achtundneunzigtausendsechshundertvierundsiebzig (98.674) Klasse B Geschäftsanteile Serie 12 und zwölftausendfünf-
hunderteinundneunzig (12.591) Klasse D Geschäftsanteile Serie 12; und
Einunddreißigtausendachthundertvierundachtzig (31.884) Klasse B Geschäftsanteile Serie 13 und neunundachtzigtau-
sendeinhundertzweiunddreißig (89.132) Klasse D Geschäftsanteile der Serie 13
jeder Geschäftsanteil hat einen Nennwert von einem US Dollar Cent (USD 0,01)“.
Da kein weiterer Beschluss auf der Tagesordnung steht, wurde die Generalversammlung geschlossen um 18.15 Uhr.
<i>Voraussichtliche kosteni>
Die voraussichtlichen Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche von der Gesellschaft
aufgrund der vorliegenden Urkunde getragen werden oder welcher der Gesellschaft in Rechnung gestellt werden, werden
ungefähr eintausenddreihundert Euros (EUR 1.300,-) betragen
<i>Erklärungi>
Diese Urkunde wurde in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, an dem am Anfang dieses Dokuments genannten
Tag aufgenommen.
Der unterzeichnete Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die Urkunde auf Anfrage der er-
schienenen Parteien auf Englisch geschrieben ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung und im Falle von Abweichungen
zwischen dem englischen und dem deutschen Text soll die englische Fassung vorrangig sein.
Nachdem das Dokument dem Bevollmächtigten der erschienenen Parteien vorgelesen worden ist, hat der Bevoll-
mächtigte dieses zusammen mit dem Notar unterzeichnet.
Gezeichnet: V. HEMERY, A. LAMBERT, C. CONSTANTINESCU, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 20 mars 2014. Relation: DIE/2014/3549. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): pr. RECKEN.
Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Memorial C.
Diekirch, den 07. April 2014.
Référence de publication: 2014049650/356.
(140057269) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2014.
F&A Prom S.à .r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2551 Luxembourg, 135, avenue du Dix Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 185.863.
STATUTS
L'an deux mille quatorze, le quatorze mars;
Pardevant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
ONT COMPARU:
1) Monsieur Marc FELTES, gérant de sociétés, né le 27 juillet 1974 à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
demeurant à L-2551 Luxembourg, 23, rue Charlemagne.
2) Monsieur Joachim LEGROCOLLARD, ingénieur, né le 22 décembre 1975 à Liège (Belgique), demeurant à B-6600
Bastogne, 3, rue des Arbalétriers.
3) Madame Nadine FELTES, gérant de sociétés, née le 2 juillet 1966 à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
demeurant à B-6781 Sélange, 29, rue du Kirchberg.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d’arrêter les statuts d’une société à responsabilité limitée
qu'ils déclarent constituer entre eux et dont les statuts ont été arrêtés comme suit:
Titre I
er
. Dénomination - Objet - Durée - Siège social
Art. 1
er
. Il est formé par la présente, entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui
pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée dénommée “F&A PROM S.à r.l.”, (ci-après la "So-
ciété"), laquelle sera régie par les présents statuts (les "Statuts") ainsi que par les lois respectives et plus particulièrement
par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la "Loi").
Art. 2. La Société a pour objet l’achat, la vente, la mise en valeur, la location d’immeubles et de tous droits immobiliers,
la prise, respectivement la mise en location de biens meubles et immeubles, la gérance, respectivement la gestion d’im-
meubles ou de patrimoines mobiliers et immobiliers tant pour son propre compte que pour compte de tiers, de même
que la promotion immobilière.
La Société pourra effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations
sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développe-
ment de ces participations.
71324
L
U X E M B O U R G
La Société pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et
à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au
développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option
d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement,
faire mettre en valeur ces affaires et brevets.
La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit.
La Société pourra, dans les limites fixées par la Loi, accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous
concours, prêts, avances ou garanties.
Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter
caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.
La Société prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelcon-
ques, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent et qui sont susceptibles de
promouvoir son développement ou extension.
Art. 3. Le siège social est établi à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu'à cessation complète des circonstances anormales. Une
telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la Société. La déclaration de transfert de siège sera faite et portée à
la connaissance des tiers par l’organe de la Société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.
Art. 4. La durée de la Société est illimitée.
Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,-EUR), représenté par cent (100) parts sociales
de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.
Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, les articles 200-1 et
200-2, entre autres, de la Loi sont d’application, c’est-à-dire chaque décision de l’associé unique ainsi que chaque contrat
entre celui-ci et la Société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les assemblées générales des associés
ne sont pas applicables.
La Société peut acquérir ses propres parts à condition qu'elles soient annulées et le capital réduit proportionnellement.
Art. 6. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune
d'elles.
S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la Société a le droit de suspendre l’exercice des droits afférents,
jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard, propriétaire de la part sociale. Il en sera de
même en cas de conflit opposant l’usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier-gagiste.
Toutefois, les droits de vote attachés aux parts sociales grevées d'usufruit sont exercés par le seul usufruitier.
Art. 7. Les cessions de parts entre vifs à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l’agrément donné en
assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social.
Les cessions de parts à cause de mort à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l’agrément donné en
assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social appartenant aux survivants.
Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont transmises à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant.
En cas de refus d'agrément dans l’une ou l’autre des hypothèses, les associés restants possèdent un droit de préemption
proportionnel à leur participation dans le capital social restant.
Le droit de préemption non exercé par un ou plusieurs associés échoit proportionnellement aux autres associés. Il
doit être exercé dans un délai de trois mois après le refus d'agrément. Le non-exercice du droit de préemption entraîne
de plein droit agrément de la proposition de cession initiale.
Art. 8. A côté de son apport, chaque associé pourra, avec l’accord préalable des autres associés, faire des avances en
compte-courant de la Société. Ces avances seront comptabilisées sur un compte-courant spécial entre l’associé, qui a fait
l’avance, et la Société.
Elles porteront intérêt à un taux fixé par l’assemblée générale des associés à une majorité des deux tiers. Ces intérêts
seront comptabilisés comme frais généraux.
Les avances accordées par un associé dans la forme déterminée par cet article ne sont pas à considérer comme un
apport supplémentaire et l’associé sera reconnu comme créancier de la Société en ce qui concerne ce montant et les
intérêts.
Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société. En cas de
décès d’un associé, la Société sera continuée entre les associés survivants et les héritiers légaux.
71325
L
U X E M B O U R G
Art. 10. Les créanciers, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, apposer
des scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration.
Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux.
Art. 11. La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci forment un conseil de gérance. Si un ou plusieurs gérants de classe A ("gérant-
A") et un ou plusieurs gérants de classe B ("gérant - B") sont nommés, les décisions du conseil de gérance doivent être
prises par au moins un gérant-A et un gérant-B.
Le pouvoir et la classe d'un gérant - A ou B - est déterminée par l’assemblée générale lors de sa nomination.
Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour accomplir les affaires de la Société et pour représenter la
Société judiciairement et extrajudiciairement.
Le ou les gérants peuvent nommer des fondés de pouvoir de la Société, qui peuvent engager la Société par leurs
signatures individuelles, mais seulement dans les limites à déterminer dans la procuration.
Art. 12. Tout gérant ne contracte à raison de sa fonction, aucune obligation personnelle, quant aux engagements
régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n'est responsable que de l’exécution de son mandat.
Art. 13. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des Statuts ne
pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.
Des dividendes intérimaires peuvent être distribués dans les conditions suivantes:
- des comptes intérimaires sont établis sur une base trimestrielle ou semestrielle,
- ces comptes doivent montrer un profit suffisant, bénéfices reportés inclus,
- la décision de payer des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés.
Art. 14. L'exercice social court du premier janvier au trente et un décembre de chaque année.
Art. 15. Chaque année, au 31 décembre, la gérance établira les comptes annuels et les soumettra aux associés.
Art. 16. Tout associé peut prendre au siège social de la Société communication des comptes annuels pendant les quinze
jours qui précéderont son approbation.
Art. 17. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales,
amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pour cent (5 %) du bénéfice net seront prélevés et affectés à la réserve légale. Ces prélèvements
et affectations cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve aura atteint un dixième du capital social, mais devront être
repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se
trouve entamé. Le solde est à la libre disposition des associés.
Art. 18. En cas de dissolution de la Société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par la gérance ou
par toute personne désignée par les associés.
La liquidation de la Société terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés en proportion des parts
sociales qu'ils détiennent.
Des pertes éventuelles sont réparties de la même façon, sans qu'un associé puisse cependant être obligé de faire des
paiements dépassant ses apports.
Art. 19. Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents Statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales en
vigueur.
Art. 20. Tous les litiges, qui naîtront pendant la liquidation de la Société, soit entre les associés eux-mêmes, soit entre
le ou les gérants et la Société, seront réglés, dans la mesure où il s’agit d’affaires de la Société, par arbitrage conformément
à la procédure civile.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2014.
<i>Souscription et libérationi>
Les Statuts ayant ainsi été arrêtés, les cent (100) parts sociales ont été souscrites comme suit:
1) Marc FELTES, prénommé, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
2) Joachim LEGROCOLLARD, prénommé, quarante parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
3) Nadine FELTES, prénommée, dix parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
Total: cent parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
71326
L
U X E M B O U R G
Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents
euros (12.500,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, est évalué à environ neuf cents euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt, les associées, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoquées, se
sont réunies en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1. Le siège social est établi à L-2551 Luxembourg, 135, avenue du X Septembre.
2. Le nombre de membres au conseil de gérance a été fixé à trois (3).
3. Les personnes suivantes ont été nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Marc FELTES, gérant de sociétés, né le 27 juillet 1974 à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
demeurant à L-2551 Luxembourg, 23, rue Charlemagne, gérant technique;
- Monsieur Joachim LEGROCOLLARD, ingénieur, né le 22 décembre 1975 à Liège (Belgique), demeurant à B-6600
Bastogne, 3, rue des Arbalétriers, gérant technique;
- Madame Nadine FELTES, épouse THEIS, gérante de sociétés, née à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le
2 juillet 1966, demeurant à B-6781 Sélange, 29, rue du Kirchberg, gérante administrative.
4. La Société est valablement engagée en toutes circonstances et sans restrictions par la signature conjointe des trois
gérants.
5. La Société exercera son activité sous l’enseigne Feltes & Associés Promotions.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu'avant toute activité commerciale de la Société
présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et
demeures, ils ont tous signé ensemble avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: M. FELTES, J. LEGROCOLLARD, N. FELTES, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 20 mars 2014. LAC/2014/12938. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société;
Luxembourg, le 3 avril 2014.
Référence de publication: 2014049756/168.
(140056466) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2014.
Immowest Lux I S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 125.553.
EXTRAIT
Il résulte d'une résolution écrite des associés de la Société en date du 20 mars 2014 que la Société a révoqué M. Gerold
Hellmich en tant que gérant de classe B de la Société avec effet au 20 mars 2014 et a nommé les personnes suivantes,
pour une durée illimitée et avec effet au 20 mars 2014 en tant que gérants de classe B de la Société:
- Mag. Daniel Riedl, né le 7 septembre 1969, à Salzbourg, Autriche avec résidence professionnelle à Hietzinger Kai 131,
A-1130 Vienne, Autriche
- Mag. Andreas Ratzinger, né le 29 novembre 1966, à Vienne, Autriche, avec résidence professionnelle à Hietzinger
Kai 131, A-1130 Vienne, Autriche
- Mr Martin Puckl, né le 1
er
décembre 1969, à Krems, Autriche, avec résidence professionnelle à Hietzinger Kai 131,
A-1130 Vienne, Autriche
- Dr. Paul Kozubek, né le 23 mars 1974, à Vienne, Autriche avec résidence professionnelle à Hietzinger Kai 131, A-1130
Vienne, Autriche.
71327
L
U X E M B O U R G
Le conseil de gérance de la Société est désormais composé comme suit:
- M. Jean (John) Wantz, gérant de classe A;
- M. Charles Meyer, gérant de classe A;
- Mag. Daniel Riedl, gérant de classe B;
- Mag. Andreas Ratzinger, gérant de classe B;
- M. Martin Puckl, gérant de classe B;
- Dr. Paul Kozubek, gérant de classe B;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
avril 2014.
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2014050253/31.
(140057262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2014.
Vela Real Estate Credit Holdings I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 35.312,50.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 152.469.
Le bilan de la société au 31.12.2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
avril 2014.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2014050159/12.
(140056560) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2014.
VDMC, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1818 Howald, 4, rue des Joncs.
R.C.S. Luxembourg B 179.532.
Le Bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014050164/9.
(140057144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2014.
VIII Chateau Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 33, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 151.561.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014050167/9.
(140057178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2014.
Waldimmo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5465 Waldbredimus, 27, rue de Trintange.
R.C.S. Luxembourg B 125.461.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014050174/9.
(140056522) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2014.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
71328
3i Infrastructure (Luxembourg) Holdings S.à r.l.
3i Infrastructure (Luxembourg) S. à r.l.
AC Revocable Trust s.à r.l.
Airsim Invest S.A.
A&K S.à r.l.
Alphatax S.à r.l.
Amarante SPF S.A.
Aperam
AS-Dusty Sàrl
ASSA ABLOY Branding S.à r.l.
Auto Sport Diffusion S.A.
Azeta SPF S.A.
Bievelez s.à r.l.
Borletti Group Management S.A.
Boulangerie-Pâtisserie Christian Schumacher S.à r.l.
By B.C. S.à r.l.
Capula Luxembourg Limited
Coparin S.A.
CPI Asia Shinjuku II S.à r.l.
Cruise Management S.à r.l.
CSN Resources S.A.
DD Constructions S.A.
ESCF Laatzen S.à r.l.
F&A Prom S.à .r.l.
FIP (Europe)
Gilmour Holdings S.à r.l.
Immowest Lux I S.à r.l.
International Partners and Associates S.A.
Marguerite Wind Butendiek S.à r.l.
multisystems S.à r.l.
Nadine SA
New Ypso Management Benetti S.C.A.
NPF Soparfi D S.à r.l.
NSK Euro Holdings S.A.
OCM Luxembourg POF IV GLP Blocker S.à r.l.
Olamobile S.à r.l.
Olivia S.A.
Orxeo S.à r.l.
Outlet Site Holdings S.à r.l.
Outlet Site JV S.à r.l.
O-Wind S.A.
Oxalya Group S.A.
Oytis S.A.
Parc Avenue Capital S.A.
Planeta Industries S.A.
secupay S.A.
Tata Consultancy Services Luxembourg S.A.
VDMC
Vela Real Estate Credit Holdings I S.à r.l.
VIII Chateau Finance S.à r.l.
Waldimmo S.A.
Zulia S.A.