logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1429

4 juin 2014

SOMMAIRE

CWICCS S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68584

ECommerce Holding II S.à r.l. . . . . . . . . . . .

68558

GreenTech  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68586

Helma Lux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68550

Kettenheim Capital SA, SICAV-FIS . . . . . .

68550

Kulczyk Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

68592

Kyoto Infrastructure S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

68549

La Française Bank  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68548

La Quessine S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68551

Leasing Events Cars  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68547

Liberty Property Trust Lux S.à r.l.  . . . . . . .

68551

LLA S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68547

Lloyd Immobilien Aktiengesellschaft S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68548

Longview Partners Investments  . . . . . . . . .

68549

Lotus Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68548

LREDS II (LBF) S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68549

LRP Luxembourg Holdings S.à r.l.  . . . . . . .

68549

Luxmob S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68554

Marnix S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68546

Mavico Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68546

MBERP (Luxembourg) 3 S.à r.l.  . . . . . . . . .

68546

mcPaLo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68592

Mediterraneo Vip S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68547

MezzVest Luxembourg III S.à r.l.  . . . . . . . .

68554

MGX Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68547

Minor Participations S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

68553

Mizzen Manco S.C.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68555

Mizzen Topco S.C.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68581

MM Construction S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

68547

Mobileo S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68552

Montaigne S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68550

Montaigne S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68553

Mostiquo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68552

Mostiquo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68552

Mostiquo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68553

Mostiquo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68551

Mostiquo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68551

MPK Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

68546

Multi City S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68551

Myriel S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68546

Nesslany S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68554

Net + Ultra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68548

Newell Luxembourg Finance S.à r.l.  . . . . .

68548

Omapiep S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68554

Oven LuxCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68553

SER Communications Sàrl  . . . . . . . . . . . . . .

68592

Soeasy Consulting  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68552

Worsley S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68550

68545

L

U X E M B O U R G

Myriel S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 33, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 139.958.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014048673/10.
(140055123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2014.

Marnix S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 58.360.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 avril 2014.

Référence de publication: 2014048674/10.
(140055048) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2014.

Mavico Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 39.946.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 avril 2014.

Référence de publication: 2014048675/10.
(140055450) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2014.

MBERP (Luxembourg) 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 153.805.

<i>Dépôt rectificatif B153805 - L130222264 enregistré et déposé le 30/12/2013

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014048676/11.
(140054882) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2014.

MPK Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2339 Luxembourg, 11, rue Christophe Plantin.

R.C.S. Luxembourg B 53.763.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31.12.2013 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg

hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Für die Gesellschaft
N. Brauer
<i>Managing Director

Référence de publication: 2014048696/13.
(140054963) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2014.

68546

L

U X E M B O U R G

Mediterraneo Vip S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 6, avenue J.-P. Pescatore.

R.C.S. Luxembourg B 122.184.

Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour MEDITERRANEO VIP S.A.
Société anonyme
FIDUCIAIRE DES P.M.E. SA

Référence de publication: 2014048680/12.
(140055213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2014.

MGX Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2561 Luxembourg, 31, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 157.365.

Par la présente, nous vous faisons part de notre décision de démissionner, avec effet immédiat, de notre mandat de

Commissaire aux Comptes de votre société, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 157365.

Luxembourg, le 1 

er

 avril 2014.

PERSKY GmbH

Référence de publication: 2014048681/12.
(140055022) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2014.

MM Construction S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 6, avenue J.-P. Pescatore.

R.C.S. Luxembourg B 83.154.

Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour MM CONSTRUCTION SARL
Société à responsabilité limitée
FIDUCIAIRE DES P.M.E. SA

Référence de publication: 2014048688/12.
(140055388) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2014.

LLA S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7480 Tuntange, 29A, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 176.567.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014048653/9.
(140055154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2014.

Leasing Events Cars, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1898 Kockelscheuer, 1, rue Robert Schuman.

R.C.S. Luxembourg B 172.851.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014048650/9.
(140055153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2014.

68547

L

U X E M B O U R G

Net + Ultra, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 256, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 56.292.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014048701/9.
(140055155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2014.

Newell Luxembourg Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 112.715.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014048703/9.
(140054905) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2014.

Lotus Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 149.399.

Le bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 03.04.14.

Référence de publication: 2014048641/10.
(140055071) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2014.

Lloyd Immobilien Aktiengesellschaft S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 107.757.

<i>Gesellschafterbeschluss der Firma Lloyd Immobilien Aktiengesellschaft S.A.

Unter Verzicht auf alle Formen und Fristen der Ladung treten wir zu einer Versammlung zusammen und beschließen

folgendes:

Die Anschrift des Verwaltungsratsmitglied sowie Delegierte des Verwaltungsrates Silvia Nickel wird wie folgt geändert:

2, rue 1900, L-2157 Luxembourg.

Luxembourg, den 03. April 2014.

<i>Für die Gesellschaft

Référence de publication: 2014048640/14.
(140055559) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2014.

La Française Bank, Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 14.361.

<i>Extrait du procès-verbal du conseil de surveillance de la Française Bank (B14361)du 02 octobre 2013

Après avoir délibéré, le Conseil de Surveillance décide à l'unanimité
- De nommer Arnaud SARFATI, né le 10 février 1975 à Bourg La Reine (France) et demeurant 41, boulevard de

Montmorency F-75016 PARIS, en tant que membre du Directoire pour une durée de 6 ans.

LASSERRE Pierre / WICKER Alain.

Référence de publication: 2014048638/12.
(140055129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2014.

68548

L

U X E M B O U R G

Kyoto Infrastructure S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 6, avenue J.-P. Pescatore.

R.C.S. Luxembourg B 145.912.

Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour KYOTO INFRASTRUCTURE S.A.
Société anonyme
FIDUCIAIRE DES P.M.E. SA

Référence de publication: 2014048636/12.
(140055127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2014.

Longview Partners Investments, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 112.878.

Le Rapport annuel révisé au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 avril 2014.

<i>Pour le Conseil d'Administration

Référence de publication: 2014048654/11.
(140055083) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2014.

LRP Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 100.217.

Les comptes annuels au 30 novembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 avril 2014.

Sophie Zintzen
<i>Mandataire

Référence de publication: 2014048657/12.
(140054962) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2014.

LREDS II (LBF) S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 177.034.

EXTRAIT

Le conseil d'administration de la Société réuni en son siège le 28 mars 2014 a décidé de mettre fin au mandat de

ABACAB S.à r.l. en tant que reviseur d'entreprises agréé.

En remplacement, L' Alliance Révision S.à r.l, société à responsabilité limitée, ayant son siège social au L-1628 Luxem-

bourg, 1, rue des Glacis, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 46498, a
été nommée réviseur d'entreprises agréé avec effet au 28 mars 2014 jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra
en 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 avril 2014.

Pour extrait sincère et conforme
Sanne Group (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2014048656/19.
(140054867) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2014.

68549

L

U X E M B O U R G

Kettenheim Capital SA, SICAV-FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investisse-

ment Spécialisé.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 172.070.

<i>Extrait de la résolution circulaire du conseil d'administration de la société du 27 mars 2014

Le conseil décide à l'unanimité d'accepter la démission de Monsieur Cédric Biart du poste d'administrateur de la société

ave effet au 20 décembre 2013.

Pour Extrait
FIDUPAR
Signatures

Référence de publication: 2014048629/14.
(140055298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2014.

Helma Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7241 Bereldange, 202, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 125.913.

<i>Auszug aus dem Protokoll vom 1. April 2014

Laut Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 1. April 2014 ergab sich folgende Änderung der Sitzes:
Alte Adresse:
49, route de diekirch, L-7220 Walferdange
Neue Adresse:
202, route de Luxembourg
L-7241 Bereldange
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 3. April 2014.

Référence de publication: 2014048591/16.
(140055394) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2014.

Montaigne S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 90.000,00.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 117.731.

Il résulte des transferts de parts sociales en date du 29 novembre 2013 que:
Thibault Management Services S.A. a transféré 1800 parts sociales à SAS Falcon Invest France ayant pour siège social

le 2405 route des Dolines, Buro Club Immeuble Le Drakkar, F-06560 Valbonne Sophia-Antipolis, France.

Luxembourg, le 3 avril 2014.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2014048671/15.
(140055548) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2014.

Worsley S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 140.919.

Par la présente nous vous informons de notre décision de dénoncer notre convention de domiciliation du 05/08/2009

avec effet immédiat, 43, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Howald, le 26/03/2014.

Luc Sunnen.

Référence de publication: 2014048868/9.
(140055050) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2014.

68550

L

U X E M B O U R G

La Quessine S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 105.972.

Le Bilan au 31.12.2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014048646/10.
(140055150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2014.

Liberty Property Trust Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 130.041.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 avril 2014.

Référence de publication: 2014048639/10.
(140055167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2014.

Mostiquo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 8, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 133.129.

Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

L-1118 Luxembourg, le 03 avril 2014.

Madame Zaklina Cubrilovic-Zupanoska
<i>Associé unique

Référence de publication: 2014048691/12.
(140055286) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2014.

Mostiquo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 8, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 133.129.

Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

L-1118 Luxembourg, le 03 avril 2014.

Madame Zaklina Cubrilovic-Zupanoska
<i>Associé unique

Référence de publication: 2014048692/12.
(140055287) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2014.

Multi City S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 113.069.

Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014048697/10.
(140054979) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2014.

68551

L

U X E M B O U R G

Mostiquo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 8, Centre Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 133.129.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

L-1118 Luxembourg, le 13 février 2014.

Madame Zaklina Cubrilovic-Zupanoska
<i>Associé unique

Référence de publication: 2014048693/12.
(140055288) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2014.

Mostiquo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 8, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 133.129.

Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

L-1118 Luxembourg, le 03 avril 2014.

Madame Zaklina Cubrilovic-Zupanoska
<i>Associé unique

Référence de publication: 2014048694/12.
(140055350) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2014.

Mobileo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 113.127.

<i>Extrait des décisions prises par le conseil d'administration en date du 24 mars 2014

Le siège social a été transféré de L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, à L-2453 Luxem-

bourg, 6, rue Eugène Ruppert.

Veuillez noter que l'adresse professionnelle de Monsieur Hans DE GRAAF, administrateur et président du conseil

d'administration, de Madame Monique JUNCKER et de Madame Valérie PECHON, administrateur, se situe désormais au
L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

Luxembourg, le 3 avril 2014.

Pour extrait et avis sincères et conformes
<i>Pour MOBILEO S.A.
Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2014048689/17.
(140055053) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2014.

Soeasy Consulting, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8279 Holzem, 28, rue de Capellen.

R.C.S. Luxembourg B 174.522.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Hesperange, le 2 avril 2014.

<i>Pour la société
Me Martine DECKER
<i>Notaire

Référence de publication: 2014048801/13.
(140054960) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2014.

68552

L

U X E M B O U R G

Mostiquo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 8, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 133.129.

Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

L-1118 Luxembourg, le 03 avril 2014.

Madame Zaklina Cubrilovic-Zupanoska
<i>Associé unique

Référence de publication: 2014048695/12.
(140055351) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2014.

Minor Participations S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 123.394.

Il résulte d'une résolution circulaire des actionnaires de la Société du 25 mars 2014, qu'il a été mis fin avec effet immédiat

au mandat de gérant de Monsieur David Heaney et au mandat de gérant de Monsieur Martin Pugh.

Monsieur Christopher Rylatt, né à Guernesey, le 8 mars 1984, avec adresse professionnelle au 3, Rue Ami-Lullin,

CH-1211 Genève a été nommé gérant de la Société avec effet immédiat.

Monsieur Paul Weir, né à Portsmouth, Royaume-Uni, le 15 août 1968, avec adresse professionnelle au Elizabeth House,

9, Castle Street, Jersey, JE2 3RT St Helier a été nommé gérant de la Société avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour MINOR PARTICIPATIONS S.à r.l.

Référence de publication: 2014048684/16.
(140055508) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2014.

Montaigne S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 90.000,00.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 117.731.

Il résulte des transferts de parts sociales en date du 29 novembre 2013 que:
Victoria Management Services S.A. a transféré 1800 parts sociales à SAS Falcon Invest France ayant pour siège social

le 2405 route des Dolines, Buro Club Immeuble Le Drakkar, F-06560 Valbonne Sophia-Antipolis, France.

Luxembourg, le 3 avril 2014.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2014048672/15.
(140055548) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2014.

Oven LuxCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J. F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 143.942.

Les statuts coordonnés au 13 mars 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Marc Loesch
<i>Notaire

Référence de publication: 2014048708/11.
(140055382) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2014.

68553

L

U X E M B O U R G

MezzVest Luxembourg III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 166.312.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 Décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 07 Mars 2014.

MezzVest Luxembourg III S.à r.l.
Paul Galliver
<i>Manager

Référence de publication: 2014048667/14.
(140055254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2014.

Luxmob S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1160 Luxembourg, 32-36, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 114.413.

<i>Extrait de la résolution écrite des membres du conseil de gérance prises en date du 28 février 2014

<i>Résolution

Les membres du Conseil de Gérance décident à l'unanimité de transférer le siège social de la Société du 34A, Boulevard

Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, au 32-36, Boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg, avec effet au

er

 mars 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 février 2014.

Référence de publication: 2014048661/14.
(140055349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2014.

Nesslany S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 178.607.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 1 

er

 avril 2014.

Référence de publication: 2014048699/10.
(140055261) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2014.

Omapiep S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.502,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 183.475.

Nous vous prions de bien vouloir prendre note des changements suivants concernant l'associé unique de la Société,

c.à.d. Annagab S.àr.l., et ce avec effet au 7 mars 2014:

- changement de la forme juridique de société à responsabilité limitée en société anonyme; et
- changement de dénomination en «Annagab S.A.».
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 avril 2014.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014048707/16.
(140055619) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2014.

68554

L

U X E M B O U R G

Mizzen Manco S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 19, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 171.028.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-fourth day of January.
Before the undersigned Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held

an extraordinary general meeting of the shareholders of Mizzen Manco S.C.A., a société en commandite par actions,

incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 15, rue Edward Steichen,
L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register
under number B 171028, incorporated pursuant to a deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, on
10 August 2012, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations no. 2356 of 21 September 2012, last
amended on 10 May 2013 pursuant to a deed of Maître Carlo Wersandt, notary residing in Luxembourg, published with
the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations no. 1827 of 30 July 2013 (the “Company”).

The meeting was opened at 12:15 a.m. CET with Ms. Christine Kröger, residing in Luxembourg, in the chair,
who appointed as secretary, Ms. Ikrame Dabaj, professionally residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mr. Georg Gerstberger, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1. Reduction of the Company’s share capital by an amount of eight thousand five hundred twenty-four pounds sterling

and fifty-nine pence (GBP 8,524.59), through the cancellation of two hundred and eighty-four thousand one hundred and
fifty-three (284,153) class B1 shares, two hundred and eighty-four thousand one hundred and fifty-three (284,153) class
B2 shares and two hundred and eighty-four thousand one hundred and fifty-three (284,153) class B3 shares held by Mr.
Nicholas Pearce in the Company; and

2. Restatement of article 6.1.1 of the Company’s articles of association to reflect the above.
II. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their

shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the represented
shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to this deed to be filed at the same time with the
registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, initialled “ne varietur” by the appearing parties will also remain annexed

to this deed.

III. That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and the shareholders present

or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no
convening notices were necessary.

IV. That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deli-

berate on all the items of the agenda.

The general meeting has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting resolves to reduce, within the scope of article 49-3 of the of the law of August 10, 1915 on

commercial companies, as amended (the “Law”), the share capital of the Company by an amount of eight thousand five
hundred  twenty-four  pounds  sterling  and  fifty-nine  pence  (GBP  8,524.59),  in  order  to  bring  the  share  capital  of  the
Company from its present amount of three hundred twenty-five thousand six hundred seventeen Pound Sterling and
forty-eight Pence (GBP 325,617.48) to a new amount of three hundred seventeen thousand ninety-two pounds sterling
and eighty-nine pence (GBP 317,092.89), by way of cancellation by the Company of two hundred and eighty-four thousand
one hundred and fifty-three (284,153) class B1 shares, two hundred and eighty-four thousand one hundred and fifty-three
(284,153) class B2 shares and two hundred and eighty-four thousand one hundred and fifty-three (284,153) class B3 shares
held by Mr. Nicholas Pearce (the “Cancelled Shares”). The counter value of the Cancelled Shares shall be paid out to Mr.
Nicholas Pearce and the general meeting therefore grants power to the general partner of the Company to proceed with
the payment of the counter-value in the aggregate amount of eight thousand five hundred twenty-four pounds sterling
and fifty-nine pence (GBP 8,524.59) to Mr. Nicholas Pearce, but not before a period of thirty days from the publication
of the present deed in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, under observance of the provisions of Article
69 of the Law.

68555

L

U X E M B O U R G

<i>Second resolution

The general meeting resolves to restate article 6.1.1 of the Company’s articles of association, which shall henceforth

read as follows:

“ Art. 6. Share capital.
6.1 Issued share capital
6.1.1 The Company’s issued share capital is set at three hundred seventeen thousand ninety-two pounds sterling and

eighty-nine pence (GBP 317,092.89), consisting of the following shares:

(a) one million one hundred fifteen thousand six hundred forty-six (1,115,646) Class A1 shares having a nominal value

of one penny (GBP 0.01) per share;

(b) one million one hundred fifteen thousand six hundred forty-two (1,115,642) Class A2 shares having a nominal value

of one penny (GBP 0.01) per share;

(c) one million one hundred fifteen thousand six hundred forty (1,115,640) Class A3 shares having a nominal value of

one penny (GBP 0.01) per share;

(d) nine million ninety-eight thousand nine hundred and thirty-three (9,098,933) Class B1 shares having a nominal value

of one penny (GBP 0.01) per share;

(e) nine million ninety-eight thousand nine hundred and twenty-eight (9,098,928) Class B2 shares having a nominal

value of one penny (GBP 0.01) per share;

(f) nine million ninety-eight thousand nine hundred and twenty-eight (9,098,926) Class B3 shares having a nominal value

of one penny (GBP 0.01) per share;

(g) three hundred fifty-five thousand one hundred ninety-two (355,192) Class C1 shares having a nominal value of one

penny (GBP 0.01) per share;

(h) three hundred fifty-five thousand one hundred ninety-one (355.191) Class C2 shares having a nominal value of one

penny (GBP 0.01) per share; and

(i) three hundred fifty-five thousand one hundred ninety-one (355,191) Class C3 shares having a nominal value of one

penny (GBP 0.01) per share.”

<i>Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are

estimated at EUR 2,000.-.

There being no further business the meeting is closed at 12:30 a.m. CET.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French translation. On express request of the same appearing
person, and in case any divergences would arise between the French and the English text, the English text will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by surname, name and residence, said

person signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L’an deux mille quatorze, le vingt-quatrième jour du mois de janvier.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

s’est déroulée

une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Mizzen Manco S.C.A., une société en commandite par

actions, constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg et ayant son siège social sis 15, rue Edward
Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 171028, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire résidant à Lu-
xembourg, en date du 10 août 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 21 septembre 2012
sous le numéro 2356. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois le 10 mai 2013 par acte de Maître Carlo Wersandt,
notaire résidant à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 30 juillet 2013 sous le
numéro 1827 (la «Société»).

L’assemblée a été ouverte à 12:15 heures sous la présidence de Mademoiselle Christine Kröger, résidant à Luxembourg,
laquelle a désigné comme secrétaire Mademoiselle Ikrame Dabaj, résidant professionnellement à Luxembourg.
L’assemblée a élu comme scrutateur Monsieur Georg Gerstberger, résidant à Luxembourg.
L’assemblée ayant été constituée, la présidente a déclaré et prié le notaire instrumentant d’acter:
I. Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

68556

L

U X E M B O U R G

<i>Ordre du jour

1. Réduction du capital social de la Société d’un montant de huit mille cinq cent vingt-quatre livres sterling et cinquante-

neuf pence (GBP 8.524,59) par l’annulation de deux cent quatre-vingt-quatre mille cent cinquante-trois (284.153) actions
de catégorie B1, deux cent quatre-vingt-quatre mille cent cinquante-trois (284.153) actions de catégorie B2 et deux cent
quatre-vingt-quatre mille cent cinquante-trois (284.153) actions de catégorie B3 détenues par M. Nicholas Pearce dans
la Société; et

2. Modification de l’article 6.1.1. des statuts de la Société;
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu'ils détiennent figurent sur une feuille de présence; cette feuille de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, signées «ne varietur», par les personnes comparantes resteront atta-

chées à cet acte.

III. Que l’intégralité du capital social est présente ou représentée à la présente assemblée et les actionnaires présents

ou représentés déclarent avoir reçu notification et avoir pris connaissance de l’ordre du jour avant la tenue de cette
assemblée, aucune convocation n’a été nécessaire.

IV. Que la présente assemblée, représentant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement sur les points portés à l’ordre du jour.

L’assemblée générale a demandé au notaire d’acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale des actionnaires décide de réduire, en application de l’article 49-3 de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi"), le capital social de la Société d’un montant de huit mille cinq cent
vingt-quatre livres sterling et cinquante-neuf pence (GBP 8.524,59) afin de le réduire de son montant actuel de trois cent
vingt-cinq mille six cent dix-sept livres sterling et quarante-huit pence (GBP 325.617,48) à un nouveau montant de trois
cent dix-sept mille quatre-vingt-douze livres sterling et quatre-vingt-neuf pence (GBP 317.092,89) par l’annulation par la
Société de deux cent quatre-vingt-quatre mille cent cinquante-trois (284.153) actions de catégorie B1, deux cent quatre-
vingt-quatre mille cent cinquante-trois (284.153) actions de catégorie B2 et deux cent quatre-vingt-quatre mille cent
cinquante-trois (284.153) actions de catégorie B3 détenues par Monsieur Nicholas Pearce (les «Actions Annulées»). La
contre-valeur des Actions Annulées sera versée à Monsieur Nicholas Pearce et l’assemblée générale donne par consé-
quent procuration à l’associé commandité de la Société de procéder au paiement de la contre-valeur d’un montant total
de huit mille cinq cent vingt-quatre livres sterling et cinquante-neuf pence (GBP 8.524,59) à Monsieur Nicholas Pearce,
ce paiement ne devant pas intervenir avant un délai de trente jours à compter de la publication du présent acte au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, conformément aux dispositions de l’Article 69 de la Loi.

<i>Deuxième Résolution

L’assemblée générale des actionnaires décide de modifier l’article 6.1.1 des statuts de la Société dans ces termes:

« Art. 6. Capital Social.
6.1 Capital souscrit
6.1.1 Le capital souscrit de la Société est établi à trois cent dix-sept mille quatre-vingt-douze livres sterling et quatre-

vingt-neuf pence (GBP 317.092,89), composé comme suit:

(a) un million cent quinze mille six cent quarante-six (1.115.646) actions de catégorie A1 ayant une valeur nominale

d’un Penny (GBP 0,01) chacune;

(b) un million cent quinze mille six cent quarante-deux (1.115.642) actions de catégorie A2 ayant une valeur nominale

d’un Penny (GBP 0,01) chacune;

(c) un million cent quinze mille six cent quarante (1.115.640) actions de catégorie A3 ayant une valeur nominale d’un

Penny (GBP 0,01) chacune;

(d) neuf millions quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent trente-trois (9.098.933) actions de catégorie B1 ayant une valeur

nominale d’un Penny (GBP 0,01) chacune;

(e) neuf millions quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent vingt-huit (9.098.928) actions de catégorie B2 ayant une valeur

nominale d’un Penny (GBP 0,01) chacune;

(f) neuf millions quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent vingt-six (9.098.926) actions de catégorie B3 ayant une valeur

nominale d’un Penny (GBP 0,01) chacune;

(g) trois cent cinquante-cinq mille cent quatre-vingt-douze (355.192) actions de catégorie C1 ayant une valeur nominale

d’un Penny (GBP 0,01) chacune;

(h) trois cent cinquante-cinq mille cent quatre-vingt-onze (355.191) actions de catégorie C2 ayant une valeur nominale

d’un Penny (GBP 0,01) chacune;

68557

L

U X E M B O U R G

(i) trois cent cinquante-cinq mille cent quatre-vingt-onze (355.191) actions de catégorie C3 ayant une valeur nominale

d’un Penny (GBP 0,01) chacune.»

<i>Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incomberont à la Société sont

estimés à EUR 2.000,-

Ne restant plus de point à l’ordre du jour, l’assemblée est close à 12:30.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, à la date indiquée au début de ce document.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par son prénom, nom

et lieu de résidence, ledit comparant a signé avec Nous, le notaire, le présent acte.

Signé: C. KRÖGER, I. DABAJ, G. GERSTBERGER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 février 2014. Relation: LAC/2014/5125. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur

 (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 8 avril 2014.

Référence de publication: 2014050647/180.
(140057779) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2014.

ECommerce Holding II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.000,00.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 7, avenue Jean-Pierre Pescatore.

R.C.S. Luxembourg B 177.435.

In the year two thousand and fourteen, on the nineteenth day of March.
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

1. Global Fin Tech Holding S.à r.l. a limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing

under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
(Registre de Commerce et des Sociétés) under number B 184.665, having its registered office at 7, avenue J.P. Pescatore,
L-2324 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (hereinafter “Global Fin Tech Holding”),

being the holder of twelve thousand four hundred ninety-nine (12,499) common shares and five thousand two hundred

fifty (5,250) series A shares,

here represented by Ms Xiaoshu Tang, LL.M., residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Berlin on 4 March

2014 and in Luxembourg on 4 March 2014;

2.  Bambino  53.  V  V  UG  (haftungsbeschränkt),  a  limited  liability  company  (Unternehmergesellschaft  (haftungsbes-

chränkt)) existing under the laws of Germany registered with the commercial register at the local court of Charlottenburg,
Germany,  under  number  HRB  126893  B,  having  its  registered  address  at  Johannisstraße  20,  10117  Berlin,  Germany
(hereinafter “Bambino 53. V V”),

being the holder of one (1) common share,
here represented by Ms Xiaoshu Tang, LL.M., residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Berlin on 4 March

2014;

3. HV Holtzbrinck Ventures Fund V GmbH &amp; Co. KG, a limited partnership (Kommanditgesellschaft) under the laws

of Germany with its statutory seat in Munich, Germany, registered with the commercial register (Handelsregister) at the
local court of Munich (Amtsgericht München), Germany, under no. HRA 98863, having its business address at Kaiserstraße
14b, 80801 Munich, Germany, represented by its general partner, HV Holtzbrinck Ventures Holding GmbH, a limited
liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) existing under the laws of Germany, registered with the com-
mercial register at the local court of München, Germany, under no. HRB 185098 B, having its registered address at
Kaiserstraße 14 b, 80801 München, Germany, (hereinafter “Holtzbrinck”), participating and voting only for purposes of
Agenda point 3 et seqq.,

becoming the holder of three thousand six hundred twenty-five (3,625) series A shares,
here represented by Ms Xiaoshu Tang, LL.M., residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Munich, Germany,

on 6 March 2014; and

68558

L

U X E M B O U R G

4. AI Lendico Holdings LLC, a limited liability company under the laws of Delaware, United States of America, registered

with the Secretary of State of the state of Delaware under registration number 5482207, with its statutory seat in 2711
Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, United States of America (hereinafter “Access” and, together
with Holtzbrinck, the “New Investors”), participating and voting only for purposes of Agenda point 3 et seqq.,

becoming the holder of three thousand six hundred twenty-five (3,625) series A shares,
here represented by Ms Xiaoshu Tang, LL.M., residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in London, United

Kingdom, on 5 March 2014.

The said proxies, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary will remain annexed

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The parties listed under 1. and 2. (the “Existing Shareholders”) are all the shareholders of ECommerce Holding II S.à

r.l. (the “Company”), a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg, having its registered office at 7, avenue Pescatore, L-2324 Luxembourg, registered with the Luxembourg
Trade and Companies’ Register under number B 177.435 and incorporated pursuant to a deed of the notary Maître Carlo
Wersandt, residing in Luxembourg, on 7 May 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
number 1651 dated 10 July 2013. The articles have been amended for the last time by deed of the undersigned notary
on 19 March 2014, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The Existing Shareholders representing the entire share capital and having waived any notice requirement, the general

meeting of shareholders is regularly constituted and may validly deliberate on the following agenda whereby the New
Investors participate and vote for the purpose of Agenda point 3 et seqq. only:

<i>Agenda:

1. Acceptance of (i) HV Holtzbrinck Ventures Fund V GmbH &amp; Co. KG, a limited partnership (Kommanditgesellschaft)

under the laws of Germany with its statutory seat in Munich, Germany, registered with the commercial register (Han-
delsregister) at the local court of Munich (Amtsgericht München), Germany, under no. HRA 98863, having its business
address at Kaiserstraße 14b, 80801 Munich, Germany, and (ii) AI Lendico Holdings LLC, a limited liability company under
the laws of Delaware, United States of America, registered with the Secretary of State of the state of Delaware under
registration number 5482207, with its statutory seat in 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808,
United States of America, as new shareholders of the Company.

2. Increase of the Company’s share capital by an amount of seven thousand two hundred fifty euro (EUR 7,250) so as

to raise it from its current amount of seventeen thousand seven hundred fifty euro (EUR 17,750) up to twenty-five
thousand euro (EUR 25,000) by issuing seven thousand two hundred fifty (7,250) Series A Shares with a nominal value
of one euro (EUR 1) each.

3. Subsequent amendment of article five (5) of the articles of association of the Company so that it shall henceforth

read as follows:

“ Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company’s share capital is set at twenty-five thousand Euros (EUR 25,000.00), represented by:
5.1.1 twelve thousand five hundred (12,500) common shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each (hereinafter

“Common Shares”) and

5.1.2 twelve thousand five hundred (12,500) series A shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each (hereinafter

“Series A Shares”, the Series A Shares hereinafter also referred to as “Preferred Shares”).

The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by these

articles of association or by the Law.

5.2 The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.3 Each of (i) Global Fin Tech Holding S.à. r.l. (“Rocket”), (ii) HV Holtzbrinck Ventures Fund V GmbH &amp; Co. KG

(“Holtzbrinck”) and (iii) AI Lendico Holdings LLC (“Access”; Rocket, Holtzbrinck and Access jointly the “Investors” and
each an “Investor”) shall be entitled to subscribe for such amount of further shares to be issued in the course of a capital
increase implementing an investment offer of a third party (being neither a shareholder nor a company affiliated to a
shareholder within the meaning of sections 15 et seqq. German Stock Corporation Act (AktG) (a “Third Party Investor”))
and which has been approved by a Super Majority (a “Third Party Investment”) - irrespective whether made by the Third
Party Investor or one or more matching shareholders - required to maintain up to its percentage ownership in the
Company prior to such capital increase under the same terms and conditions on which the Third Party Investment is
based on. The respective Investor shall inform the Company by binding declaration within three (3) weeks if it intends
to exercise its right pursuant to the foregoing sentence of this Article 5.3.”

4. Full restatement of the articles of association of the Company so that they shall henceforth shall as follows:

68559

L

U X E M B O U R G

“A. Name - Purpose - Duration - Registered Office

Art. 1. Name. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name ECommerce

Holding II S.à r.l. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning com-
mercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.

Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign

companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio.

2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it

holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the
Company.

2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by

issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.

2.4 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities

which it considers useful for the accomplishment of these purposes, in view of its realisation by sale, exchange or other-
wise.

Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Art. 4. Registered Office.
4.1 The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by decision of the board of managers. It

may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by resolution of the shareholders,
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution

of the board of managers.

4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances

or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
traordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwiths-
tanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

B. Share Capital - Shares

Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company’s share capital is set at twenty-five thousand Euros (EUR 25,000.00), represented by:
5.1.1 twelve thousand five hundred (12,500) common shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each (hereinafter

“Common Shares”) and

5.1.2 twelve thousand five hundred (12,500) series A shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each (hereinafter

“Series A Shares”, the Series A Shares hereinafter also referred to as “Preferred Shares”).

The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by these

articles of association or by the Law.

5.2 The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.3 Each of (i) Global Fin Tech Holding S.à. r.l. (“Rocket”), (ii) HV Holtzbrinck Ventures Fund V GmbH &amp; Co. KG

(“Holtzbrinck”) and (iii) AI Lendico Holdings LLC (“Access”; Rocket, Holtzbrinck and Access jointly the “Investors” and
each an “Investor”) shall be entitled to subscribe for such amount of further shares to be issued in the course of a capital
increase implementing an investment offer of a third party (being neither a shareholder nor a company affiliated to a
shareholder within the meaning of sections 15 et seqq. German Stock Corporation Act (AktG) (a “Third Party Investor”))
and which has been approved by a Super Majority (a “Third Party Investment”) - irrespective whether made by the Third
Party Investor or one or more matching shareholders - required to maintain up to its percentage ownership in the
Company prior to such capital increase under the same terms and conditions on which the Third Party Investment is
based on. The respective Investor shall inform the Company by binding declaration within three (3) weeks if it intends
to exercise its right pursuant to the foregoing sentence of this Article 5.3.

Art. 6. Shares.
6.1 The Company’s share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.

68560

L

U X E M B O U R G

6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of

the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.

6.5 The Company may accept contributions without issuing shares or other securities in consideration and may allocate

such contributions to one or more distributable reserves. Decisions as to the use of any such distributable reserves are
to be taken by the shareholder(s) or the manager(s) as the case may be, subject to the Law and these articles of association.

Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection

by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.

7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall

appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.

7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given

by the shareholders at a majority of three quarters of the share capital and subject to the provisions of any shareholders
agreement between the shareholders, if any, in particular, any rights of first refusal, rights of pre-emption or tag-along
rights or drag along rights contained in any shareholders’ agreement between the shareholders. To the extent that such
approval has been granted, an additional consent to the transfer of shares is not required:

7.4.1 in any case of a transfer, assignment or any other disposal of shares by any Investor to a company affiliated to

such Investor within the meaning of sections 15 et seqq. German Stock Corporation Act (AktG);

7.4.2 in case of a sale, transfer, assignment or any other disposal of shares by any Investor to a company (x) which is

directly or indirectly Controlling, Controlled by or under common Control with (i) this Investor or (ii) by one or more
direct or indirect shareholders of the respective Investor (each a “Controlled Company”), whereas “Control” or “Con-
trolled” or “Controlling” shall mean the direct or indirect domination of the company by way of (a) managing the company
as managing shareholder, (b) holding the majority of shares or (c) holding the majority of voting rights by means of a
contractual voting pool, or (d) the unilateral ability to cause, directly or indirectly, the direction of the management and
policies of a person, whether through the ownership of voting securities or otherwise, or (y) in which the respective
Investor or one or more shareholders of such Investor has a direct or indirect majority shareholding;

7.4.3 in case of a transfer, assignment or any other disposal of shares (i) to a party acquiring shares under the simplified

employee participation or (ii) to the Company and/or any Investor pursuant to a call-option under a vesting scheme;

7.4.4 in case of any transfer, assignment or any other disposal of shares within the framework of transformation

procedures pursuant to the transformation law of Luxembourg, in particular (but without limitation) a merger of the
Company, if the shareholders of the Company hold more than fifty per cent (50%) in any surviving legal entity after such
transformation procedure.

7.5 In the cases provided for in art. 7.4.1 through 7.4.4 above, no duties to offer for sale apply, nor do any rights of

first refusal, rights of pre-emption or tag-along rights or drag-along rights in favour of other shareholders apply.

7.6 Any transfer, assignment or any other disposal of shares shall become effective towards the Company and third

parties through the notification of the transfer, assignment or any other disposal to, or upon the acceptance of the transfer,
assignment or any other disposal by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

7.7 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject

to the approval of such transfer given by shareholders holding at least three quarters of the share capital (a “Super
Majority”) (which, for these purposes, shall exclude the shares of the deceased shareholder). Such approval is, however,
not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse or any other legal
heir of the deceased shareholder.

Art. 8. Liquidation and sale preferences.
8.1 In case (i) of any sale of at least fifty percent (50%) of all shares in the Company, or a swap or a take-over of the

Company in an economically comparable way in a single or more related transactions or in close time proximity to one
another, or (ii) of the liquidation of the Company or (iii) of any sale or transfer of shares in the Company either to third
parties or other shareholders that would result in either more than fifty percent (50%) of the share capital or more than
fifty percent (50%) of the voting rights being owned by the acquiring party/parties (change of control) as a result of one
or more related acquisitions, (each of the events described in (i), (ii) and (iii) is hereinafter referred to as a “Liquidity
Event”), the proceeds (“Exit Proceeds”) - subject to Article 8.2 below - will be distributed in accordance with Article 8.3
to the shareholders pro rata corresponding to their participation in the Liquidity Event.

8.2 On a preferred level (“Preferred Level”) the holders of Series A Shares shall receive an amount which equals the

amount of their respective total investment made in the Company (consisting of the nominal amount of the Series A
Shares acquired by that holder and any share premium and/or other capital contribution (account 115) paid by that holder

68561

L

U X E M B O U R G

to the Company). If the Exit Proceeds do not suffice for the payments to be made on the Preferred Level, the Exit Proceeds
shall be allocated to the holders of Series A Shares pro rata to the amounts that would have been allocated to the holders
of Series A Shares on the Preferred Level if the Exit Proceeds were sufficient.

8.3 After the payments on the Preferred Level have been made, the remaining Exit Proceeds shall be allocated on a

common level (“Common Level”) to all shareholders pro rata corresponding to their participation in the Liquidity Event.
Any amounts received by any shareholder on the Preferred Level shall reduce the amount to be allocated to such sha-
reholder on the Common Level and shall be allocated subsequently pursuant to this Common Level provided that no
shareholder shall be obliged to repay any amount received on the Preferred Level. The allocation at the Common Level
shall be made until all Exit Proceeds have been distributed to the shareholders. Irrespective of whether or not the sale
of shares is made in one Liquidity Event or after the Liquidity Event in one transaction or more transactions no shareholder
shall receive for the sale of all of its shares (and shall repay any exceeding amount to the other shareholders) an amount
exceeding the higher of (i) its share in the total Exit Proceeds or proceeds pro rata to the shares sold on a common
equivalent basis or (ii) the amount allocated to such shareholder on the Preferred Level from a subsequent sale. All rights
related to the liquidity preference stipulated herein can only be exercised once.

8.4 The preferred allocation on the Preferred Level applies to each of the respective Preferred Shares as long as on

the respective Preferred Shares the respective amount stipulated in Article 8.2 has not yet been distributed once.

Art. 9. Redemption of Shares.
9.1 The Company may redeem its own shares. The voting rights of any of its shares held by the Company are suspended,

for as long as they are held by the Company.

9.2 Shares of a shareholder may be redeemed without such shareholder’s consent, if:
9.2.1 insolvency proceedings are opened over the assets of the shareholder or the opening of insolvency proceedings

is rejected for lack of assets;

9.2.2 the share of a shareholder is seized or enforcement proceedings are otherwise initiated against such share and

such enforcement proceedings are not finally closed within two (2) months.

Upon receipt by such shareholder of the declaration of redemption sent by the board of managers, the shares shall

automatically be redeemed without any further action being required. The present articles together with the declaration
of redemption constitute together a valid instrument in writing for the purposes of article 190 of the Law and the Company
hereby acknowledges and accepts the transfer of the shares in such case and undertakes to register the transfer in its
share register and to proceed with the relevant filings required by law.

9.3 If the share is held by several persons, it is sufficient that the ground for redemption exists with respect to one

person; independently of this, several jointly entitled persons can only exercise the shareholders’ rights in a uniform way
through one jointly entitled person to be appointed for this purpose without undue delay after the joint entitlement
arises.

9.4 The board of managers may declare a redemption. The redemption declaration takes effect upon receipt of the

declaration by the shareholder concerned and if a respective shareholders’ resolution is adopted (except in case of Article
9.2 of these articles of association, in which no declaration by the shareholder concerned and no respective shareholders’
resolution is required).

Art. 10. Compensation for Redemption.
10.1 Redemption is made against compensation.
10.2 The compensation consists of a total amount equal to the market value of the redeemed shares. The effective

date is the date before the redemption resolution.

10.3 The compensation for redemption shall be due and payable immediately upon redemption of the shares.
10.4 The withdrawing shareholder shall not be entitled to request the Company to provide security for outstanding

amounts including interest.

10.5 In the event of dispute regarding the amount of the payable redemption compensation this is to determine by an

auditor as expert arbitrator who shall jointly be appointed by the shareholders. If no agreement is reached the expert
arbitrator shall be selected by the President of the Tribunal d’Arrondissement upon request of a shareholder or of the
Company. The decision of the expert arbitrator shall be binding. The costs of the expert opinion shall be borne by the
Company and the requesting shareholder in equal parts, the part allocated to such shareholder shall be set off with the
redemption price and the redemption price shall be reduced accordingly. The shareholder shall bear the remaining costs
in case the redemption price does not cover the costs allocated to the shareholder for the expert opinion.

Art. 11. Request of Assignment in lieu of Redemption.
11.1 The Company may decide that, in lieu of redemption, the shareholder concerned shall transfer the shares to a

person named by the Company (including another shareholder of the Company), including also partial redemption or
partial assignment of the shares to the Company or to a person named by the Company.

11.2 This Article 11 applies with the proviso that the compensation, as provided for in Article 10 of these articles of

association, for the shares to be assigned is owed by the person acquiring the shares and that the Company shall be liable
like a guarantor.

68562

L

U X E M B O U R G

C. Decisions of the shareholders

Art. 12. Collective decisions of the shareholders.
12.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these

articles of association.

12.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
12.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise

conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case,
each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his
vote in writing.

12.4 The shareholders’ resolutions are passed in meetings. Unless mandatory law prescribes another form, they can

also be passed outside meetings in writing (including e-mail or fax) or telephone voting if such procedure is requested by
a shareholder and no other shareholder declares its dissent with the procedure within two (2) weeks towards the board
of managers of the Company in written form. If no dissent is declared within the two (2) weeks pursuant to the foregoing
sentence the votes of the shareholders which are not participating in the voting shall be deemed to be abstention from
voting. Written resolutions must be signed by each shareholder and the written record must be sent to each shareholder
without undue delay. Resolutions not passed in writing must be confirmed in writing. Such confirmation only has decla-
ratory significance.

12.5 Unless a notarial record is made of shareholders’ resolutions, a written record must be made of every resolution

passed at shareholders’ meetings (for purposes of proof, not as a precondition of validity) without undue delay, which
must state the date and form of the resolution passed, the content of the resolution and the votes cast. The written
record must be sent to each shareholder in writing without undue delay.

12.6 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of

shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by
the sole shareholder.

Art. 13. General meetings of shareholders.
13.1 Meetings of shareholders may be held at the registered office of the Company or at such place and time as may

be specified in the respective convening notices of meeting.

13.2  The  shareholders’  meeting  is  called  by  registered  letter  (registered  personal  delivery,  registered  delivery  or

registered letter with confirmation of receipt) to each shareholder, stating the place, date, time and agenda, with a period
of notice of at least four (4) weeks for ordinary shareholders’ meetings and at least two (2) weeks for extraordinary
shareholders’ meetings. The period of notice begins to run on the day following postage. The day of the shareholders’
meeting is not counted in the calculation of the period of notice.

13.3 If all shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived convening

requirements, the meeting may be held without prior notice.

13.4 Each shareholder is entitled to be accompanied or represented at the shareholders’ meeting by another share-

holder authorised by a written power of attorney or by a lawyer, tax advisor or auditor under a professional duty of
confidentiality.

13.5 Unless a notarial record is made of the negotiations of the shareholders’ meeting, a written record must be made

concerning the course of the meeting (for purposes of proof, not as a precondition of validity), which must state the place
and date of the meeting, the participants, the items on the agenda, the main content of the negotiations and the share-
holders’ resolutions.

The written record must be signed by all shareholders present or represented in the shareholders’ meeting (for

purposes of proof, not as a precondition of validity). Each shareholder must be sent a copy of the written record.

Art. 14. Quorum and vote.
14.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
14.2 A shareholders’ meeting only constitutes a quorum if at least 50% of the share capital is represented. Save for a

higher majority provided in these articles of association or by Law, collective decisions of the Company’s shareholders
are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share capital. If there is
no quorum, a new shareholders’ meeting with the same agenda must be called without undue delay in compliance with
Article 13.2. This shareholders’ meeting then shall constitute a quorum regardless of the share capital represented, if this
was pointed out in the notice calling the meeting and the decisions shall be taken at the majority of the votes cast.

Art. 15. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.

Art. 16. Amendments of articles of association. Any amendment of these articles of association requires the approval

of (i) a majority in number of shareholders (ii) who are also a Super Majority.

68563

L

U X E M B O U R G

Art. 17. Shareholders’ resolutions requiring specific majority.
17.1 Shareholders’ Resolutions regarding the following subjects must be taken by a Super Majority:
17.1.1 disposition of all Company’s assets or of a significant part of the Company’s assets including the resolution with

respect to the liquidation of the Company;

17.1.2 resolution with respect to the merger, separation and transformation of the Company;
17.1.3  conclusion  of  intra-group  agreements  (Unternehmensverträge  within  the  meaning  of  sections  291  et  seqq.

German Stock Corporation Act (AktG));

17.1.4 conclusion of company participations (for the avoidance of doubt, other than by way of disposal of shares) of

any kind including silent partnerships and all agreements by which the other contractual party is granted a participation
in the Company’s profit or any payment that is dependent on the amount of the Company’s profit; this does not include
agreements with shareholders or employees of the Company, including agreements concluded in light of a prospective
status as shareholder or employee, as well as agreements with third parties within the ordinary course of business, e.g.
agreements between the Company and advertising partners.

17.2 Resolutions regarding the following subjects must be taken by a Super Majority and also require the prior consent

of the Investors:

17.2.1 exclusion of subscription rights in case of capital increases;
17.2.2 acquisition of the Company’s own shares, with the exception of acquisitions in accordance with Article 9.2 and

transfers in accordance with Article 11.1 of these articles of association.

17.3. Whenever the capital of the Company is divided into different classes of shares the specific rights and obligations

attached to any class may be varied or abrogated with the unanimous consent in writing of the shareholders who hold
all the issued shares of that class.

D. Board of managers - Advisory board

Art. 18. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
18.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers

form a board of managers.

18.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not

expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of
association is to be construed as a reference to the “sole manager”.

18.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any

actions necessary or useful to fulfil the Company’s corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the
Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.

Art. 19. Election, removal and term of office of managers.
19.1 The manager(s) shall be elected by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration

and term of office.

19.2 The managers shall be elected and may be removed from office at any time, with or without cause.
19.3 The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two (2) different classes, being class A

managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant
shareholders resolutions and the managers be identified with respect to the class they belong.

Art. 20. Vacancy in the office of a manager.
20.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or

otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the  replaced manager  by the remaining  managers  until  the  next  meeting  of  shareholders which  shall resolve on the
permanent appointment, in compliance with the applicable legal provisions.

20.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company’s sole manager, such vacancy must be filled without undue

delay by the general meeting of shareholders.

Art. 21. Convening meetings of the board of managers.
21.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held

at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.

21.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers at least twenty-four (24)

hours in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such document being
sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined
in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.

68564

L

U X E M B O U R G

21.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive

any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of
managers.

Art. 22. Management.
22.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not

need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

22.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may

appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any
such meeting.

22.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either

in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.

22.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other

means of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis
and allowing an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a
participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.

22.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or

represented at a meeting of the board of managers.

22.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,

if any, shall not have a casting vote. In the event however the general meeting of shareholders has appointed different
classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only
be validly taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which
may be represented).

22.7 The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in

writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be
the date of the last signature.

22.8 The managers shall require the prior consent of at least two (2) of the shareholders Rocket, Holtzbrinck and

Access which at the relevant time hold jointly more than 50% of the Company’s registered share capital (the “Investor
Majority”) for the legal transactions and measures of the company which are beyond the ordinary course of business of
the Company and - in any case - for the legal transactions and measures specified below.

No consent is required if such legal transactions and measures have been precisely defined and have in advance been

approved by an adopted budget with the consent of the Investor Majority:

22.8.1 formation, acquisition, closure or disposal of enterprises or partial businesses;
22.8.2 amendment of statutes, these articles of association, shareholder agreements and similar contracts as well as

exercise (or waiver) of shareholders’ rights in companies in which an interest is held;

22.8.3 acquisition, sale and encumbrance of real estate and similar rights or rights in real estate;
22.8.4 establishment, relocation and closure of branch establishments and places of business;
22.8.5 modification of the fields of business of the Company and the termination of existing and commencement of

new fields of business (Geschäftsfelder);

22.8.6 approval of the annual plan, in particular the budget plan for each following year;
22.8.7 assumption of sureties, guarantees or similar liabilities in excess of an amount of two hundred thousand Euros

(EUR 200,000.00) in aggregate;

22.8.8 granting of loans in excess of two hundred thousand Euros (EUR 200,000.00) in the individual case, excluding,

however, such loans between the Company and direct and indirect subsidiaries of the Company;

22.8.9 conclusion and termination of credit and loan agreements and other financial agreements in excess of two

hundred thousand Euros (EUR 200,000.00) in the individual case and amendments to the credit framework and extraor-
dinary repayments, excluding, however, such agreements between the Company and direct and indirect subsidiaries of
the Company;

22.8.10 futures transactions concerning currencies, securities and exchange-traded goods and rights as well as other

transactions with derivative financial instruments;

22.8.11 granting, introduction and amendment of pension commitments of any kind;
22.8.12 conclusion, amendment and dissolution of employment contracts providing for a remuneration in excess of

one hundred fifty thousand Euros (EUR 150,000) per year;

22.8.13 promise or granting of bonuses and gratuities of any kind outside of existing employment contracts as well as

payment of advances or grant of loans to managers and employees in excess of fifty thousand Euros (EUR 50,000) in the
individual case;

68565

L

U X E M B O U R G

22.8.14 conclusion, amendment or termination of Company collective agreements, works agreements (of substantial

importance) and of general guidelines regarding the Company pension scheme;

22.8.15 institution and termination of legal disputes, in particular, arbitration proceedings involving a judicial amount

in controversy of more than ten thousand Euros (EUR 10,000.00) in the individual case;

22.8.16 acquisition, disposition and/or licensing of rights of use of any kind with respect to intellectual property rights

including copyrights or any other property rights as well as the passing on of know-how for the independent exploitation
by  the  enterprise  and/or  a  third  party,  as  well  as  the  grant  or  acquisition  of  licences,  as  well  as  the  amendment  of
agreements with respect thereto, excluding, however, such dispositions between the Company and direct and indirect
subsidiaries of the Company;

22.8.17 granting of a power of attorney, by which a proxy grants power of attorney to another proxy, in order to

conclude an agreement with him at the expense of the Company;

22.8.18 transactions of the Company and its investment companies with affiliated legal entities and individuals. As such

shall be deemed to be direct or indirect shareholders of the Company (including, for the avoidance of doubt, European
Founders Fund GmbH (“EFF”) and EFF’s direct and indirect shareholders (i.e. the Samwer brothers)), but excluding any
direct or indirect shareholders of Holtzbrinck and/or Access, affiliated companies pursuant to sections 15 et seqq. German
Stock Corporation Act (AktG) as well as relatives pursuant to section 15 German Tax Code (AO) of direct or indirect
shareholders, as far as the latter (except EFF and EFF’s direct and indirect shareholders) - individually or jointly - hold,
directly or indirectly, a majority interest. The consent requirement pursuant to this Article 22.8.18 does not apply if the
transaction belongs to the ordinary course of business of the Company and is at arm’s length;

22.8.19 changing of the Company’s auditors;
22.8.20 granting, setting up or amending any employee incentive scheme (including the grant of any share options)

outside the existing simplified employee participation agreed upon between the shareholders in a shareholders’ agree-
ment;

22.8.21 exercise of voting rights and other rights in a company in which the Company is a shareholder to the extent

that this exercise would require the consent of the Investor Majority under these articles of association if the Company
was concerned, i.e. according to this Article 22.8 or Article 17;

22.9 If the consent is required as aforesaid for the acquisition, sale or encumbrance of objects, the consent is also

required for the contractual obligation relating thereto. The shareholders’ meeting may by resolution determine further
transactions and measures requiring the consent of the Investor Majority. The Investor Majority may give its consent also
in advance for certain groups and kinds of transactions and measures.

22.10 The shareholders may by shareholders’ resolution adopt rules of procedure for the managers.
22.11 The management shall ensure that, as far as legally possible, the regulations in this Article 22 apply in the same

manner to all related companies in which the Company holds a majority interest, directly or indirectly, at present or in
the future.

Art. 23. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
23.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by

the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. In the event the general meeting of
shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers), such minutes
shall be signed by one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation). Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman,
if any, or by any two (2) managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of
managers (namely class A managers and class B managers), such copies or excerpts shall be signed by one (1) class A
manager and one (1) class B manager (including by way of representation).

23.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or

excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.

Art. 24. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the

signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers;
in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A manager
and class B manager), the Company will only be validly bound by the joint signature of at least one (1) class A manager
and one (1) class B manager (including by way of representation) or (ii) by the joint signatures or the sole signature of
any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such
delegation.

Art. 25. Advisory board.
25.1 The Company shall have an advisory board. It shall consist of six (6) voting members. The shareholders’ meeting

may by way of a shareholders’ resolution increase or decrease the number of voting members of the advisory board.

25.2 The shareholders’ meeting shall only set and/or amend rules of procedure for the advisory board by way of a

unanimous shareholders’ resolution.

68566

L

U X E M B O U R G

25.3 The voting members of the advisory board shall be nominated, withdrawn or replaced by each member’s res-

pective appointing shareholder by written notification towards the Company as follows:

25.3.1 Four (4) voting members of the advisory board shall be nominated by the shareholder Rocket in its sole dis-

cretion;

25.3.2 One (1) voting member of the advisory board shall be nominated by the shareholder Holtzbrinck in its sole

discretion; and

25.3.3 One (1) voting member of the advisory board shall be nominated by the shareholder Access in its sole discretion.
25.4 The advisory board may have non-voting members of the advisory board as observers.
25.5 The advisory board shall have a chairman and a deputy chairman. A voting member nominated by Rocket shall

be the chairman of the advisory board. The rules of procedure of the advisory board may provide for further provisions
in particular on the self organization of the advisory board. The advisory board shall adopt resolutions with the simple
majority of votes cast. The advisory board shall hold meetings on a regular basis, at least once every calendar quarter.

25.6 The advisory board shall be competent for advising the Company’s managers on the strategy and operational

matters and shall discuss with the managers the budget of the Company.

25.7 The advisory board is not a supervisory board within the meaning of article 60bis-11 et seq. of the Law.

E. Audit and Supervision

Art. 26. Auditor(s).
26.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company

shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.

26.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting

of shareholders.

26.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
26.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d’entreprises agréé

(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies’ register and the
accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.

26.5 An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its

approval.

F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends

Art. 27. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end

on the thirty-first of December of the same year.

Art. 28. Annual accounts and allocation of profits.
28.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of

the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.

28.2 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve.

This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten
per cent (10%) of the share capital of the Company.

28.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the

contributing shareholder agrees with such allocation.

28.4 In case of a share capital reduction, the Company’s legal reserve may be reduced in proportion so that it does

not exceed ten per cent (10%) of the share capital.

28.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the

remainder of the Company’s annual net profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.

28.6 Subject to Article 8, distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they

hold in the Company.

Art. 29. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
29.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared

by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed shall
be allocated where applicable in accordance with the provisions of Article 8 and may not exceed realized profits since
the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable reserves, but decreased by losses
carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles of association do not allow to be
distributed.

29.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the share-

holders subject to the provisions of the Law and these articles of association.

68567

L

U X E M B O U R G

G. Liquidation

Art. 30. Liquidation. In the event of dissolution of the Company in accordance with Article 3.2 of these articles of

association, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting
of shareholders deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless other-
wise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realization of the assets and payment of the
liabilities of the Company.

H. Final clause - Governing law

Art. 31. Governing law.
31.1 All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the Law and any

shareholders’ agreement which may be entered into from time to time between the shareholders and the Company, and
which may supplement certain provisions of these articles. Where any matter contained in these articles conflicts with
the provisions of any shareholders’ agreement, such shareholders’ agreement shall prevail inter partes and to the extent
permitted by Luxembourg law.

31.2 These articles are worded in English followed by a German translation; in case of divergence between the English

and the German text, the English version shall prevail.”

5. Miscellaneous.

Having duly considered each item of the agenda, the general meeting of shareholders unanimously takes the following

resolutions:

<i>First resolution

The general meeting of shareholders accepts (i) Holtzbrinck and (ii) Access, aforementioned, as new shareholders of

the Company.

<i>Second resolution

The general meeting of shareholders resolves to increase the share capital of the Company by an amount of seven

thousand two hundred fifty euro (EUR 7,250) so as to raise it from its current amount of seventeen thousand seven
hundred fifty euro (EUR 17,750) up to twenty-five thousand euro (EUR 25,000) by issuing seven thousand two hundred
fifty (7,250) Series A Shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.

<i>Subscription

The new Series A Shares have been duly subscribed as follows:
- three thousand six hundred twenty-five (3,625) Series A Shares have been subscribed by Holtzbrinck, aforementioned,

here represented as aforementioned, for the price of three thousand six hundred twenty-five euro (EUR 3,625); and

- three thousand six hundred twenty-five (3,625) Series A Shares have been subscribed by Access, aforementioned,

here represented as aforementioned, for the price of three thousand six hundred twenty-five euro (EUR 3,625).

<i>Payment

The three thousand six hundred twenty-five (3,625) Series A Shares subscribed by Holtzbrinck, aforementioned, have

been entirely paid up through a contribution in cash in an amount of three thousand six hundred twenty-five euro (EUR
3,625).

The three thousand six hundred twenty-five (3,625) Series A Shares subscribed by Access, aforementioned, have been

entirely paid up through a contribution in cash in an amount of three thousand six hundred twenty-five euro (EUR 3,625).

The amount of seven thousand two hundred and fifty Euro (EUR 7,250.-) is as now available tot he Company, as has

been proved to the undersigned notary.

The contribution in the amount of seven thousand two hundred fifty euro (EUR 7,250) is entirely allocated to the

share capital.

<i>Third resolution

The general meeting of shareholders resolves the amendment of article five (5) of the articles of association of the

Company so that it shall henceforth read as follows:

“ Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company’s share capital is set at twenty-five thousand Euros (EUR 25,000.00), represented by:
5.1.1 twelve thousand five hundred (12,500) common shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each (hereinafter

“Common Shares”) and

5.1.2 twelve thousand five hundred (12,500) series A shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each (hereinafter

“Series A Shares”, the Series A Shares hereinafter also referred to as “Preferred Shares”).

68568

L

U X E M B O U R G

The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by these

articles of association or by the Law.

5.2 The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.3 Each of (i) Global Fin Tech Holding S.à. r.l. (“Rocket”), (ii) HV Holtzbrinck Ventures Fund V GmbH &amp; Co. KG

(“Holtzbrinck”) and (iii) AI Lendico Holdings LLC (“Access”; Rocket, Holtzbrinck and Access jointly the “Investors” and
each an “Investor”) shall be entitled to subscribe for such amount of further shares to be issued in the course of a capital
increase implementing an investment offer of a third party (being neither a shareholder nor a company affiliated to a
shareholder within the meaning of sections 15 et seqq. German Stock Corporation Act (AktG) (a “Third Party Investor”))
and which has been approved by a Super Majority (a “Third Party Investment”) - irrespective whether made by the Third
Party Investor or one or more matching shareholders - required to maintain up to its percentage ownership in the
Company prior to such capital increase under the same terms and conditions on which the Third Party Investment is
based on. The respective Investor shall inform the Company by binding declaration within three (3) weeks if it intends
to exercise its right pursuant to the foregoing sentence of this Article 5.3.”

<i>Fourth resolution

Inter alia as a result of the foregoing, the general meeting of shareholders resolves to fully restate the articles of

association of the Company which shall henceforth read as set out in the agenda of the present deed.

There being no further business, the meeting is closed.

<i>Costs and Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are

estimated at approximately EUR 3,200.-.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,

the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing party and
in case of divergence between the English and the German text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name

and residence, the said proxyholder signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausendvierzehn, am neunzehnten März.
Vor uns, dem unterzeichnenden Notar Maître Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxem-

burg.

SIND ERSCHIENEN:

1. Global Fin Tech Holding S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) ge-

gründet und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und
Gesellschaftsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) unter der Nummer B 184.665, mit Sitz in 7, avenue J.P.
Pescatore, L-2324 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg („Global Fin Tech Holding“),

Inhaber  von  zwölftausendvierhundertneunundneunzig  (12.499)  Stammanteilen  und  fünftausendzweihundertfünfzig

(5.250) Anteilen der Serie A,

hier vertreten durch Frau Xiaoshu Tang, LL.M., wohnhaft in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht, ausgestellt in Berlin

am 4. März 2014 und in Luxemburg am 4. März 2014;

2. Bambino 53. V V UG (haftungsbeschränkt), eine Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) bestehend unter

deutschem Recht, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland, unter der Nummer
HRB 126893 B, mit Sitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Deutschland („Bambino 53. V V“),

Inhaber eines (1) Stammanteils,
hier vertreten durch Frau Xiaoshu Tang, LL.M., wohnhaft in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 4. März 2014,

ausgestellt in Berlin;

3. HV Holtzbrinck Ventures Fund V GmbH &amp; Co. KG, eine Kommanditgesellschaft nach deutschem Recht mit sat-

zungsmäßigem Sitz in München, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München, Deutschland,
unter der Nummer HRA 98863, mit Geschäftssitz in Kaiserstraße 14b, 80801 München, Deutschland, vertreten durch
ihren unbeschränkt haftenden Gesellschafter, HV Holtzbrinck Ventures Holding GmbH, eine Gesellschaft mit beschränk-
ter Haftung bestehend unter deutschem Recht, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München, Deutschland,
unter der Nummer HRB 185098 B, mit Sitz in Kaiserstraße 14b, 80801 München, Deutschland („Holtzbrinck“), aus-
schließlich für die Punkte 3 ff. der Tagesordnung teilnahme- und stimmberechtigt,

zukünftiger Inhaber von dreitausendsechshundertfünfundzwanzig (3.625) Anteilen der Serie A,

68569

L

U X E M B O U R G

hier vertreten durch Frau Xiaoshu Tang, LL.M., wohnhaft in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 6. März 2014,

ausgestellt in München, Deutschland, und

4. Al Lendico Holdings LLC, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (limited liability company) nach dem Recht

des Bundesstaates Delaware, Vereinigte Staaten von Amerika, eingetragen im Secretary of State des Bundesstaates De-
laware unter der Eintragungsnummer 5482207, mit satzungsmäßigem Sitz in 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilming-
ton,  Delaware  19808,  Vereinigte  Staaten  von  Amerika  („Access“  und  gemeinschaftlich  mit  Holtzbrinck  die  „Neuen
Investoren“), ausschließlich für die Punkte 3 ff. der Tagesordnung teilnahme- und stimmberechtigt,

zukünftiger Inhaber von dreitausendsechshundertfünfundzwanzig (3.625) Anteilen der Serie A,
hier vertreten durch Frau Xiaoshu Tang, LL.M., wohnhaft in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 5. März 2014,

ausgestellt in London, Vereinigtes Königreich.

Besagte Vollmachten, welche von der Bevollmächtigten der erschienenen Parteien und dem Notar ne varietur para-

phiert wurden, werden der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.

Die unter Punkt 1 und 2 aufgelisteten Parteien (die „Bestehenden Gesellschafter“) sind alle Gesellschafter der ECom-

merce Holding II S.à r.l. (die „Gesellschaft“), einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée),
gegründet und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 7, avenue Pescatore, L-2324
Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 177.435, gegründet
am 7. Mai 2013 gemäß einer Urkunde des Notars Maître Carlo Wersandt, mit Amtssitz in Luxemburg, welche am 10. Juli
2013 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1651 veröffentlicht wurde. Die Satzung der Gesell-
schaft wurde zuletzt am 19. März 2014 gemäß einer Urkunde des unterzeichnenden Notars geändert, welche noch nicht
im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht wurde.

Da die Bestehenden Gesellschafter das gesamte Gesellschaftskapital vertreten und auf jegliche Ladungsformalitäten

verzichtet haben, ist die Gesellschafterversammlung ordnungsgemäß zusammengekommen und kann wirksam über die
folgende Tagesordnung verhandeln, wobei die Neuen Investoren ausschließlich für die Punkte 3 ff. der Tagesordnung
teilnahme- und stimmberechtigt sind:

<i>Tagesordnung:

1. Aufnahme von (i) HV Holtzbrinck Ventures Fund V GmbH &amp; Co. KG, einer Kommanditgesellschaft nach deutschem

Recht mit satzungsmäßigem Sitz in München, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München,
Deutschland, unter der Nummer HRA 98863, mit Geschäftssitz in Kaiserstraße 14b, 80801 München, Deutschland, und
(ii) Al Lendico Holdings LLC, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (limited liability company) nach dem Recht des
Bundesstaates Delaware, Vereinigte Staaten von Amerika, eingetragen im Secretary of State des Bundesstaates Delaware
unter  der  Eintragungsnummer  5482207,  mit  satzungsmäßigem  Sitz  in  2711  Centerville  Road,  Suite  400,  Wilmington,
Delaware 19808, Vereinigte Staaten von Amerika, als neue Gesellschafter der Gesellschaft.

2. Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von siebzehntausendsiebenhun-

dertfünfzig Euro (EUR 17.750) um einen Betrag von siebentausendzweihundertfünfzig Euro (EUR 7.250) auf einen Betrag
von fünfundzwanzigtausend Euro (EUR 25.000) durch die Ausgabe von siebentausendzweihundertfünfzig (7.250) Anteilen
der Serie A mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Anteil.

3. Anschließende Änderung des Artikels fünf (5) der Satzung der Gesellschaft, welcher nunmehr wie folgt lautet:

„ Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt fünfundzwanzigtausend Euro (EUR 25.000), bestehend aus:
5.1.1 zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteilen mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Anteil

(die „Stammanteile”), und

5.1.2 zwölftausendfünfhundert (12.500) Anteilen der Serie A mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro

Anteil (die „Anteile der Serie A”, die auch als „Vorzugsanteile“ bezeichnet werden).

Die mit den Anteilen verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es wird in dieser Satzung oder

durch das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.

5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-

zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.

5.3 Jede der Gesellschaften (i) Global Fin Tech Holding S.à r.l. („Rocket“), (ii) HV Holtzbrinck Ventures Fund V GmbH

&amp; Co. KG („Holtzbrinck“) und (iii) Al Lendico Holdings LLC („Access“; Rocket, Holtzbrinck und Access gemeinschaftlich
die „Investoren“ und jeweils ein „Investor“) ist zur Zeichnung einer Anzahl weiterer bei einer Kapitalerhöhung ausgege-
benen Anteile berechtigt, wodurch ein Investmentangebot eines Dritten umgesetzt wird (bei dem es sich weder um einen
Gesellschafter, noch um eine mit einem Gesellschafter verbundene Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. des deutschen
Aktiengesetzes (AktG) (ein „Drittinvestor“) handelt), und der vom Beirat zugestimmt wurde (eine „Investition eines
Dritten“) - unabhängig davon, ob diese vom Drittinvestor oder von einem oder mehreren vergleichbaren Gesellschaftern
erfolgte - die zur Erhaltung der Beteiligungsquote an der Gesellschaft vor einer solchen Kapitalerhöhung erforderlich ist,
und dies zu denselben Bedingungen, wie bei einer Investition eines Dritten. Der jeweilige Investor hat die Gesellschaft
durch eine verbindliche Erklärung innerhalb von drei (3) Wochen darüber zu unterrichten, ob er sein Recht gemäß des
vorstehenden Satzes dieses Artikels 5.3 ausüben möchte.“

68570

L

U X E M B O U R G

4. Gänzliche Neufassung der Satzung der Gesellschaft, welche nunmehr wie folgt lautet:

„A. Name - Zweck - Dauer - Sitz

Art. 1. Name. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen

ECommerce Holding II S.à r.l. (die „Gesellschaft“), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über
Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Ge-

sellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder
auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kontrolle
und Entwicklung ihrer Beteiligungen.

2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder

Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören Garantien geben,
Sicherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.

2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere

durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und
Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheinen bzw. Wertpapieren.

2.4 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur sowie

solche, welche geistiges Eigentum oder Grundeigentum betreffen, vornehmen, die ihr zur Erreichung dieser Zwecke
förderlich erscheinen, im Hinblick auf deren Verwertung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Art.

Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden,

welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird.

Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in der Stadt Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Rates der Geschäftsführer

verlegt werden. Durch einen Gesellschafterbeschluss, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und
Weise gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer im

Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.

4.4 Sollte der Rat der Geschäftsführer entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale

Entwicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an
ihrem  Gesellschaftssitz  beeinträchtigen  könnten,  so  kann  der  Gesellschaftssitz  bis  zur  endgültigen  Beendigung  dieser
außergewöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben
keine Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes
eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt fünfundzwanzigtausend Euro (EUR 25.000), bestehend aus:
5.1.1 zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteilen mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Anteil

(die „Stammanteile”), und

5.1.2 zwölftausendfünfhundert (12.500) Anteilen der Serie A mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro

Anteil (die „Anteile der Serie A”, die auch als „Vorzugsanteile“ bezeichnet werden).

Die mit den Anteilen verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es wird in dieser Satzung oder

durch das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.

5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-

zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.

5.3 Jede der Gesellschaften (i) Global Fin Tech Holding S.à r.l. („Rocket“), (ii) HV Holtzbrinck Ventures Fund V GmbH

&amp; Co. KG („Holtzbrinck“) und (iii) Al Lendico Holdings LLC („Access“; Rocket, Holtzbrinck und Access gemeinschaftlich
die „Investoren“ und jeweils ein „Investor“) ist zur Zeichnung einer Anzahl weiterer bei einer Kapitalerhöhung ausgege-
benen Anteile berechtigt, wodurch ein Investmentangebot eines Dritten umgesetzt wird (bei dem es sich weder um einen
Gesellschafter, noch um eine mit einem Gesellschafter verbundene Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. des deutschen
Aktiengesetzes (AktG) (ein „Drittinvestor“) handelt), und der vom Beirat zugestimmt wurde (eine „Investition eines
Dritten“) - unabhängig davon, ob diese vom Drittinvestor oder von einem oder mehreren vergleichbaren Gesellschaftern
erfolgte - die zur Erhaltung der Beteiligungsquote an der Gesellschaft vor einer solchen Kapitalerhöhung erforderlich ist,
und dies zu denselben Bedingungen, wie bei einer Investition eines Dritten. Der jeweilige Investor hat die Gesellschaft

68571

L

U X E M B O U R G

durch eine verbindliche Erklärung innerhalb von drei (3) Wochen darüber zu unterrichten, ob er sein Recht gemäß des
vorstehenden Satzes dieses Artikels 5.3 ausüben möchte.

Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit jeweils dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht über-

schreiten darf.

6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, die Insolvenz oder ein ver-

gleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.

6.5 Die Gesellschaft kann Einlagen ohne Ausgabe von Anteilen oder anderen Sicherheiten als Gegenleistung annehmen

und diese einer oder mehreren ausschüttbaren Rücklagen zuführen. Entscheidungen bezüglich der Verwendung solcher
ausschüttbarer Rücklagen werden gegebenenfalls von dem(den) Gesellschafter(n) oder Geschäftsführer(n) unter Berück-
sichtigung des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung getroffen.

Art. 7. Anteilsregister - Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden

kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.

7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten

wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft
ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.

7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.
7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern, die

mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals halten und vorbehaltlich der Bestimmungen von Gesellschafterverein-
barungen zwischen den Gesellschaftern, sofern vorhanden, insbesondere vorbehaltlich Vorkaufsrechten, Bezugsrechten
oder  Mitverkaufsrechten-  oder  Pflichten  aus  Gesellschaftervereinbarungen  zwischen  den  Gesellschaftern  übertragen
werden. Sofern eine solche Zustimmung erteilt wurde, ist eine weitere Einwilligung zur Übertragung von Anteilen nicht
erforderlich:

7.4.1 bei einem Verkauf, einer Übertragung, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung durch einen der Inves-

toren an eine mit dem betreffenden Investor verbundene Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. des deutschen Aktiengesetzes
(AktG);

7.4.2 bei einem Verkauf, einer Übertragung, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen durch

einen Investor an eine Gesellschaft, (x) welche direkt oder indirekt (i) diesen Investor oder (ii) einen oder mehrere direkte
oder indirekte Gesellschafter des betreffenden Investors (jeweils eine „Kontrollierte Gesellschaft“) Kontrolliert, von
diesem Kontrolliert wird, oder unter der gemeinsamen Kontrolle von diesem steht, wobei die Worte „Kontrolle“ oder
„Kontrolliert“ oder „Kontrolliert Werden“ die direkte oder indirekte Beherrschung der Gesellschaft bezeichnet, durch
(a) die Leitung der Gesellschaft durch einen geschäftsführenden Gesellschafter, (b) das Halten der Mehrheit der Anteile
oder (c) das Halten der Mehrheit der Stimmrechte durch eine vertragliche Stimmvereinbarung, oder (d) die einseitige
Fähigkeit, direkt oder indirekt die Leitung der Geschäftsführung und Handlungsweisen einer Person, entweder durch das
Halten stimmberechtigter Wertpapiere oder anderweitig, zu beeinflussen, oder (y) in welcher der betreffende Investor
oder einer oder mehrere Gesellschafter dieses Investors eine direkte oder indirekte Mehrheitsbeteiligung haben;

7.4.3 bei einer Übertragung, einer Abtretung oder einer Veräußerung von Anteilen (i) an einen Dritten, welcher Anteile

unter der vereinfachten Mitarbeiterbeteiligung erwirbt, oder (ii) an die Gesellschaft und/oder einen beliebigen Investor
gemäß einer Call-Option im Zusammenhang mit einer Vesting-Regelung;

7.4.4 bei einer Übertragung, Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen im Rahmen von Umwandlungs-

vorgängen gemäß des Umwandlungsrechts Luxemburgs, insbesondere (jedoch nicht beschränkt auf) eine Verschmelzung
der Gesellschaft, sofern die Gesellschafter der Gesellschaft nach einem solchen Umwandlungsvorgang mehr als fünfzig
Prozent (50%) in einer überlebenden juristischen Person halten.

7.5 In den in Artikel 7.4.1 bis 7.4.4 vorgesehenen Fällen gelten weder Verpflichtungen zu Verkaufsangeboten, noch

Vorkaufsrechte, Bezugsrechte oder Mitverkaufsrechte- oder Pflichten zugunsten anderer Gesellschafter.

7.6 Eine Übertragung, Abtretung oder andere Veräußerung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten

gemäß Artikel 1690 des Code Civil wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung, Abtretung oder anderen
Veräußerung in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung, Abtretung oder anderen Veräußerung zugestimmt hat.

7.7 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters nur an neue Gesellschafter übertragen werden,

wenn Gesellschafter, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals (eine „Qualifizierte Mehrheit“) halten, einer
solchen Übertragung zustimmen (wobei die Anteile des verstorbenen Gesellschafters für diese Zwecke nicht berück-
sichtigt werden). Eine derartige Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn die Anteile an Eltern, Nachkommen oder den/

68572

L

U X E M B O U R G

die überlebende/n Ehepartner/in oder jeden anderen gesetzlichen Erben des verstorbenen Gesellschafters übertragen
werden.

Art. 8. Liquidations- und Verkaufspräferenzen.
8.1  Im  Falle  (i)  eines  Verkaufs  von  mindestens  fünfzig  Prozent  (50%)  aller  Anteile  an  der  Gesellschaft  oder  eines

Tausches oder einer Übernahme der Gesellschaft in wirtschaftlich vergleichbarer Weise in einer oder mehreren Trans-
aktionen oder in zeitlicher Nähe zueinander, oder (ii) der Liquidation der Gesellschaft oder (iii) des Verkaufs oder der
Übertragung von Anteilen an der Gesellschaft entweder an Dritte oder an andere Gesellschafter, was dazu führen würde,
dass entweder mehr als fünfzig Prozent (50%) des Gesellschaftskapitals oder mehr als fünfzig Prozent (50%) der Stimm-
rechte im Besitz der erwerbenden Partei bzw. Parteien wären (change of control), als Ergebnis eines oder mehrerer
verbundener Akquisitionen, (wobei jeder der unter (i), (ii) und (iii) beschriebenen Fälle im Folgenden als „Liquiditätser-
eignis“ bezeichnet wird), werden die Erlöse („Exiterlöse“) - vorbehaltlich des Artikels 8.2 - im Einklang mit Artikel 8.3
auf einer pro rata-Basis entsprechend ihrer Beteiligung am Liquiditätsereignis an die Gesellschafter verteilt.

8.2 Auf einer bevorzugten Ebene („Vorzugsebene”) erhalten die Inhaber von Anteilen der Serie A einen Betrag, welcher

dem Betrag ihrer jeweiligen Gesamtinvestition in die Gesellschaft entspricht (bestehend aus dem Nominalbetrag der von
diesem Inhaber erworbenen Anteile der Serie A und dem Agio und/oder anderen Kapitaleinlage (Konto 115 des Stan-
dardisierten Luxemburgischen Kontenplans), die von diesem Inhaber an die Gesellschafter gezahlt wurden). Sind nicht
ausreichend Exiterlöse für die Zahlungen auf der Vorzugsebene vorhanden, so werden die Exiterlöse an die Inhaber der
Anteile der Serie A auf einer pro-rata Basis zu den Beträgen verteilt, die an die Inhaber der Anteile der Serie A auf der
Vorzugsebene verteilt worden wären, wenn ausreichend Exiterlöse vorhanden gewesen wären.

8.3 Nachdem die Zahlungen auf der Vorzugsebene geleistet wurden, werden die übrigen Exiterlöse auf einer gemein-

samen Ebene („Gemeinsame Ebene“) an alle Gesellschafter auf einer pro rata-Basis entsprechend ihrer Beteiligung am
Liquiditätsereignis verteilt. Sämtliche von einem Gesellschafter auf der Vorzugsebene erhaltenen Beträge mindern den
von diesem Gesellschafter zu erhaltenden Betrag auf der Gemeinsamen Ebene und werden anschließend entsprechend
dieser Gemeinsamen Ebene zugeteilt, mit der Maßgabe, dass kein Gesellschafter zur Rückzahlung eines auf der Vorzugs-
ebene erhaltenen Betrags verpflichtet ist. Die Zuteilung auf der Gemeinsamen Ebene erfolgt solange, bis alle Exiterlöse
an die Gesellschafter verteilt wurden. Unabhängig davon, ob der Verkauf von Anteilen während eines Liquiditätsereignisses
oder danach in einer oder mehreren Transaktionen erfolgt oder nicht, hat kein Gesellschafter für den Verkauf all seiner
Anteile einen Betrag zu erhalten (und übersteigende Beträge an die anderen Gesellschafter zurückzuzahlen), der höher
ist, (i) als sein Anteil an der Gesamtheit der Exiterlöse oder Erlöse auf einer pro rata-Basis zu den Anteilen, die auf einer
gemeinsamen und gleichwertigen Basis verkauft wurden oder (ii) als der Betrag, der diesem Gesellschafter auf der Vor-
zugsebene  aus  einem  späteren  Verkauf  zugeteilt  wurde.  Sämtliche  mit  der  hierin  festgelegten  Liquiditätspräferenz
verbundenen Rechte können nur einmal ausgeübt werden.

8.4 Die bevorzugte Zuteilung auf der Vorzugsebene gilt für alle entsprechenden Vorzugsanteile solange, wie bei den

jeweiligen Vorzugsanteilen der jeweils in Artikel 8.2 festgelegte Betrag noch nicht verteilt wurde.

Art. 9. Rückkauf von Anteilen.
9.1 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen. Die Stimmrechte der von der Gesellschaft gehaltenen

Anteile werden so lange ausgesetzt, wie die Anteile von der Gesellschaft gehalten werden.

9.2 Anteile eines Gesellschafters können ohne Zustimmung eines solchen zurückgekauft werden, wenn:
9.2.1 ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des Gesellschafters eröffnet wird oder die Eröffnung eines Insolvenz-

verfahrens mangels Masse abgelehnt wird;

9.2.2 der Anteil des Gesellschafters gepfändet wurde oder Vollstreckungsverfahren anderweitig gegen diesen Anteil

eingeleitet wurden und diese Verfahren nicht innerhalb von zwei (2) Monaten vollständig eingestellt sind.

Mit Erhalt durch den Gesellschafter der vom Rat der Geschäftsführer gesendeten Rückkaufserklärung sind die Anteile

automatisch zurückgekauft, ohne dass es einer weiteren Handlung bedarf. Die vorliegende Satzung stellt gemeinsam mit
der Rückkaufserklärung ein gültiges Dokument im Sinne des Artikels 190 des Gesetzes von 1915 dar und die Gesellschaft
bestätigt hiermit die Kenntnisnahme der Übertragung der Anteile, akzeptiert diese und verpflichtet sich zur Eintragung
dieser Übertragung in ihrem Anteilsregister und zur entsprechenden gesetzlich geforderten Hinterlegung für diesen Fall.

9.3 Wird der Anteil von mehreren Personen gehalten, ist das Vorliegen eines Grundes zum Rückkauf in Bezug auf eine

Person ausreichend; unabhängig davon können mehrere gemeinschaftlich berechtigte Personen die Gesellschafterrechte
nur dann und einheitlich ausüben, wenn eine der gemeinschaftlich berechtigten Personen unverzüglich nach Eintritt der
gemeinschaftlichen Berechtigung zu diesem Zwecke ernannt wird.

9.4 Ein Rückkauf kann durch den Rat der Geschäftsführer erklärt werden. Die Rückkaufserklärung wird wirksam, sobald

der betreffende Gesellschafter die Erklärung erhält und ein entsprechender Gesellschafterbeschluss gefasst wird (außer
im Falle von Artikel 9.2 dieser Satzung, in welchem keine Erklärung des Gesellschafters und kein entsprechender Gesell-
schafterbeschluss erforderlich sind).

Art. 10. Ausgleichszahlung für den Rückkauf.
10.1 Der Rückkauf erfolgt gegen eine Ausgleichszahlung.

68573

L

U X E M B O U R G

10.2 Die Ausgleichszahlung besteht aus einem Gesamtbetrag, welcher dem Marktwert der zurückgekauften Anteile

entspricht. Als Stichtag gilt der Tag vor dem Rückkaufsbeschluss.

10.3 Die Ausgleichszahlung für den Rückkauf ist unmittelbar mit dem Rückkauf der Anteile fällig und zahlbar.
10.4 Der ausscheidende Gesellschafter ist nicht dazu befugt, von der Gesellschaft Sicherheiten für ausstehende Beträge

zuzüglich Zinsen zu verlangen.

10.5 Bei Streitigkeiten hinsichtlich des Betrags der zu zahlenden Ausgleichszahlung ist dieser Betrag von einem Wirt-

schaftsprüfer  in  der  Eigenschaft  als  Schiedsgutachter,  der  von  den  Gesellschaftern  gemeinschaftlich  ernannt  wird,
festzulegen. Wird über die Ernennung des Schiedsgutachters keine Einigung erzielt, so wird dieser auf Ersuchen eines
Gesellschafters oder der Gesellschaft vom Vorsitzenden des Bezirksgerichts (Tribunal d’Arrondissement) bestimmt. Die
Entscheidung des Schiedsgutachters ist bindend. Die Kosten für das Gutachten werden von der Gesellschaft und dem
betreffenden Gesellschafter zu gleichen Teilen getragen, wobei der vom Gesellschafter zu tragende Teil mit dem Rück-
kaufspreis verrechnet und der Rückkaufspreis dementsprechend herabgesetzt wird. Der Gesellschafter hat die übrigen
Kosten zu tragen, sofern der Rückkaufspreis die dem Gesellschafter zugewiesenen Kosten für das Gutachten nicht deckt.

Art. 11. Abtretung anstelle von Rückkauf.
11.1 Die Gesellschaft kann entscheiden, dass der betreffende Gesellschafter anstelle des Rückkaufs die Anteile an eine

von der Gesellschaft benannte Person (einschließlich eines anderen Gesellschafters) zu übertragen hat, auch im Falle eines
Teilrückkaufs oder einer Teilabtretung der Anteile an die Gesellschaft oder an eine von der Gesellschaft benannte Person.

11.2 Der vorliegende Artikel 11 gilt mit der Maßgabe, dass, wie in Artikel 10 dieser Satzung vorgesehen, die Aus-

gleichszahlung  für  die  abzutretenden  Anteile  durch  die  die  Anteile  erwerbende  Person  geschuldet  ist  und  dass  die
Gesellschaft als Garant haftet.

C. Entscheidungen der Gesellschafter

Art. 12. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
12.1 Die Gesellschafterversammlung ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch das Gesetz und diese Satzung

ausdrücklich vorbehalten sind.

12.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.
12.3  Falls  und  solange  die  Gesellschaft  nicht  mehr  als  fünfundzwanzig  (25)  Gesellschafter  hat,  dürfen  gemeinsame

Entscheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung vorbehalten wären, schriftlich gefasst werden. In die-
sem Fall erhält jeder Gesellschafter den Text der zu fassenden Beschlüsse oder Entscheidungen in ausformulierter Form
und übt sein Stimmrecht schriftlich aus.

12.4 Gesellschafterbeschlüsse werden in Versammlungen gefasst. Sofern nicht zwingende gesetzliche Vorschriften eine

andere Form vorschreiben, können sie auch außerhalb von Versammlungen in schriftlicher Form (einschließlich E-Mail
oder Fax) oder durch telefonische Abstimmung gefasst werden, sofern ein solches Verfahren von einem Gesellschafter
ersucht wird und kein anderer Gesellschafter innerhalb von zwei (2) Wochen in schriftlicher Form Widerspruch gegen
dieses Verfahren gegenüber dem Rat der Geschäftsführer der Gesellschaft einlegt. Wird innerhalb von zwei (2) Wochen
kein Widerspruch gemäß des vorstehenden Satzes eingelegt, so werden die Stimmen der nicht an der Abstimmung teil-
nehmenden Gesellschafter als Enthaltungen gewertet. Schriftliche Beschlüsse sind von jedem Gesellschafter zu unter-
zeichnen und die Niederschrift ist jedem Gesellschafter unverzüglich zuzusenden. Beschlüsse, welche nicht in schriftlicher
Form gefasst werden, sind schriftlich zu bestätigen. Eine solche Bestätigung hat ausschließlich feststellende Bedeutung.

12.5 Von jedem Beschluss, der in Gesellschafterversammlungen gefasst wurde, ist unverzüglich eine Niederschrift

anzufertigen (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die Wirksamkeit), die das Datum und die Form des gefassten
Beschlusses, den Inhalt des Beschlusses und die abgegebenen Stimmen zu enthalten hat, es sei denn, die Gesellschafter-
beschlüsse wurden notariell beurkundet. Die Niederschrift muss jedem Gesellschafter unverzüglich in schriftlicher Form
zugesendet werden.

12.6 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschriften

des Abschnitts XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jede Bezugnahme auf die „Gesell-
schafterversammlung“ in der vorliegenden Satzung als Bezugnahme auf den Alleingesellschafter, je nach Zusammenhang
und soweit anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingesellschafter
ausgeübt.

Art. 13. Gesellschafterversammlung.
13.1 Gesellschafterversammlungen finden am Sitz der Gesellschaft oder an einem Ort und zu einer Zeit statt, welche

in der entsprechenden Einladung genauer bestimmt werden.

13.2  Die  Gesellschafterversammlung  wird  mittels  Einschreiben  (Zustellung  zu  eigenen  Händen,  Einschreiben  oder

Einschreiben mit Rückschein) an jeden Gesellschafter einberufen und beinhaltet den Ort, das Datum, die Uhrzeit und die
Tagesordnung,  wobei  bei  ordentlichen  Gesellschafterversammlungen  eine  Ankündigungsfrist  von  mindestens  vier  (4)
Wochen und bei außerordentlichen Gesellschafterversammlungen eine Ankündigungsfrist von mindestens zwei (2) Wo-
chen einzuhalten ist. Die Ankündigungsfrist beginnt am Tag nach dem Versand. Der Tag der Gesellschafterversammlung
wird bei der Berechnung der Ankündigungsfrist nicht berücksichtigt.

68574

L

U X E M B O U R G

13.3 Falls alle Gesellschafter in einer Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten sind und auf Einladungs-

formalitäten verzichtet haben, kann die Versammlung auch ohne vorherige Ankündigung abgehalten werden.

13.4  Jeder  Gesellschafter  ist  dazu  berechtigt,  bei  der  Gesellschafterversammlung  von  einem  anderen  durch  eine

schriftliche Vollmacht dazu berechtigten Gesellschafter oder von einem Anwalt, Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer
unter der Berufsverschwiegenheitspflicht begleitet oder vertreten zu werden.

13.5 Eine Niederschrift hinsichtlich des Ablaufs der Versammlung ist (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die

Wirksamkeit) anzufertigen und hat den Ort und das Datum der Versammlung, die Teilnehmer, die Tagesordnungspunkte,
den Hauptinhalt der Verhandlungen und die Gesellschafterbeschlüsse zu beinhalten, es sei denn, die Verhandlungen der
Gesellschafterversammlung wurden notariell beurkundet.

Die Niederschrift ist von allen bei der Gesellschafterversammlung anwesenden oder vertretenen Gesellschaftern zu

unterzeichnen  (als  Nachweis, nicht  als Voraussetzung  für  die  Wirksamkeit). Jedem Gesellschafter ist eine  Kopie  der
Niederschrift zuzusenden.

Art. 14. Quorum und Abstimmung.
14.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.
14.2 Eine Gesellschafterversammlung ist nur dann beschlussfähig, wenn mindestens 50% des Gesellschaftskapitals ver-

treten sind. Vorbehaltlich anderer Regelungen dieser Satzung oder des Gesetzes von 1915, die ein höheres Mehrheits-
verhältnis vorsehen, bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von Gesellschaftern, die
mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals innehaben. Bei Beschlussunfähigkeit ist unverzüglich im Einklang mit Artikel
13.2 eine neue Gesellschafterversammlung mit derselben Tagesordnung einzuberufen. Diese Gesellschafterversammlung
ist dann unabhängig von dem vertretenen Gesellschaftskapital beschlussfähig, sofern darauf in der die Versammlung ein-
berufenden Ladung hingewiesen wurde und Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.

Art. 15. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.

Art. 16. Änderung der Satzung.  Eine  Änderung  dieser  Satzung  erfordert  die  Zustimmung  (i)  einer  zahlenmäßigen

Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die gleichzeitig eine Qualifizierte Mehrheit darstellen.

Art. 17. Beschlüsse, die eine bestimmte Mehrheit erfordern.
17.1 Gesellschafterbeschlüsse hinsichtlich der folgenden Angelegenheiten erfordern eine Qualifizierte Mehrheit:
17.1.1 Veräußerung des gesamten Gesellschaftsvermögens oder eines beträchtlichen Anteils des Gesellschaftsvermö-

gens einschließlich des Beschlusses hinsichtlich der Liquidation der Gesellschaft;

17.1.2 Beschluss hinsichtlich der Verschmelzung, Ausgliederung und Umwandlung der Gesellschaft;
17.1.3 Abschluss von Unternehmensverträgen (im Sinne der §§ 291 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG));
17.1.4 Abschluss von Unternehmensbeteiligungen (um Zweifel auszuschließen, nicht durch die Veräußerung von An-

teilen) jeglicher Art einschließlich stiller Beteiligungen und sämtlicher Verträge, durch welche die andere Vertragspartei
eine Beteiligung am Gewinn der Gesellschaft erhält oder jede Zahlung, welche vom Gewinnbetrag der Gesellschaft ab-
hängig ist; dies umfasst nicht Verträge mit Gesellschaftern oder Angestellten der Gesellschaft, einschließlich Verträge,
welche im Hinblick auf einen voraussichtlichen Status als Gesellschafter oder Angestellter abgeschlossen wurden, sowie
Verträge mit Dritten innerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs, z.B. Verträge zwischen der Gesellschaft und Werbe-
partnern.

17.2 Beschlüsse hinsichtlich der folgenden Angelegenheiten erfordern eine Qualifizierte Mehrheit und zudem die vor-

herige Zustimmung der Investoren:

17.2.1 Ausschluss von Bezugsrechten im Falle von Kapitalerhöhungen;
17.2.2 Erwerb eigener Anteile der Gesellschaft, mit Ausnahme der Erwerbe gemäß Artikel 9.2 und Übertragungen

gemäß Artikel 11.1 dieser Satzung.

17.3  Ist  das  Gesellschaftskapital  in  verschiedene  Anteilsklassen  unterteilt,  so  können  die  spezifischen  Rechte  und

Pflichten im Zusammenhang mit einer Anteilsklasse mit der einstimmigen und schriftlichen Zustimmung der Gesellschaf-
ter, die alle ausgegebenen Anteile dieser Anteilsklasse halten, verändert oder aufgehoben werden.

D. Rat der Geschäftsführer - Beirat

Art. 18. Befugnisse des alleinigen Geschäftsführers - Zusammensetzung und Befugnisse des Rates der Geschäftsführer.
18.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Ge-

schäftsführer hat, bilden diese einen Rat der Geschäftsführer.

18.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „alleiniger Ge-

schäftsführer“ nicht ausdrücklich in dieser Satzung verwendet wird, ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Rat der
Geschäftsführer“ als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer“ auszulegen.

18.3 Der Rat der Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, im Namen der Gesellschaft zu handeln

und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.

68575

L

U X E M B O U R G

Art. 19. Ernennung, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
19.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung ernannt, welche ihre Bezüge und

ihre Amtszeit festlegt.

19.2 Die Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund ernannt oder abberufen werden.
19.3 Die Gesellschafterversammlung kann die Ernennung von Geschäftsführern zwei (2) unterschiedlicher Kategorien

beschließen, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Eine solche Klassifizierung
der Geschäftsführer muss ordnungsgemäß in der Niederschrift des betreffenden Gesellschafterbeschlusses festgehalten
und die Geschäftsführer der Kategorie, der sie angehören, zugeordnet werden.

Art. 20. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
20.1  Scheidet  ein  Geschäftsführer  durch  Tod,  Geschäftsunfähigkeit,  Insolvenz,  Rücktritt  oder  aus  einem  anderem

Grund aus seinem Amt aus, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen
die ursprüngliche Amtszeit des ersetzten Geschäftsführers nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesell-
schafterversammlung ausgefüllt werden, welche im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die
endgültige Ernennung entscheidet.

20.2 Für  den  Fall,  dass  der  alleinige  Geschäftsführer aus  seinem Amt  ausscheidet, muss die  frei gewordene  Stelle

unverzüglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.

Art. 21. Einladung zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
21.1 Der Rat der Geschäftsführer versammelt sich auf Einberufung durch einen Geschäftsführer. Die Sitzungen des

Rates der Geschäftsführer finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.

21.2  Die  Geschäftsführer  werden  mindestens  vierundzwanzig  (24)  Stunden  vor  dem  für  die  Sitzung  anberaumten

Zeitpunkt zu jeder Sitzung des Rates der Geschäftsführer schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe
der Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Geschäftsführer
per Post, Fax, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abgegeben haben, wobei
eine Kopie eines solchen Dokuments ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung zu Sitzungen des Rates der Ge-
schäftsführer ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss des Rates der Geschäftsführer
bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.

21.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle

Einladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Rates
der Geschäftsführer diesen zustimmen und diese unterzeichnen.

Art. 22. Geschäftsführung.
22.1 Der Rat der Geschäftsführer kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Rat der Ge-

schäftsführer kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise selbst ein Geschäftsführer sein muss
und der für die Protokollführung der Sitzungen des Rates der Geschäftsführer verantwortlich ist.

22.2 Sitzungen des Rates der Geschäftsführer werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Rates der Ge-

schäftsführer geleitet. In dessen Abwesenheit kann der Rat der Geschäftsführer einen anderen Geschäftsführer durch
einen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Mitglieder als Vorsitzenden pro tempore ernennen.

22.3 Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer teilnehmen, indem er einen anderen

Geschäftsführer schriftlich oder durch Faxschreiben, per E-Mail oder durch ein anderes vergleichbares Kommunikati-
onsmittel bevollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Geschäftsführer
kann einen oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.

22.4 Eine Sitzung des Rates der Geschäftsführer kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein

anderes Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu
hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel
ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung gilt als am Sitz der Ge-
sellschaft abgehalten.

22.5 Der Rat der Geschäftsführer kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest eine Mehrheit der

Geschäftsführer in einer Sitzung anwesend oder vertreten ist.

22.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Rates der Geschäftsführer

teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden,
hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme. Sofern die Gesellschafterversammlung allerdings un-
terschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäfts-
führer der Kategorie B), werden Beschlüsse des Rates der Geschäftsführer nur dann wirksam gefasst, wenn sie von der
Mehrheit der Geschäftsführer einschließlich mindestens eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsfüh-
rers der Kategorie B (oder deren Vertreter) gefasst werden.

22.7 Der Rat der Geschäftsführer kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung,

per Faxschreiben, oder per E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Jeder Geschäftsführer
kann  seine  Zustimmung  getrennt  erteilen,  wobei  die  Gesamtheit  aller  schriftlichen  Zustimmungen  die  Annahme  des

68576

L

U X E M B O U R G

betreffenden Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Be-
schlusses.

22.8 Die Geschäftsführer benötigen die vorherige Zustimmung von mindestens zwei (2) der Gesellschafter Rocket,

Holtzbrinck und Access, die zum gegebenen Zeitpunkt gemeinsam mehr als 50% des eingetragenen Gesellschaftskapital
der Gesellschaft halten (die „Mehrheit der Investoren“) für solche Rechtsgeschäfte und Maßnahmen der Gesellschaft, die
außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs der Gesellschaft liegen und - in jedem Fall - für die unten genannten Rechts-
geschäfte und Maßnahmen.

Eine Zustimmung ist nicht erforderlich, sofern solche Rechtsgeschäfte und Maßnahmen präzise definiert und im Voraus

von einem bewilligten Haushaltsplan mit der Zustimmung der Mehrheit der Investoren genehmigt wurden:

22.8.1 Gründung, Erwerb, Schließung oder Veräußerung von Unternehmen oder Teilbetrieben;
22.8.2 Änderung der Statuten, dieser Satzung, Gesellschaftervereinbarungen und ähnlicher Verträge sowie die Aus-

übung (oder der Ausschluss) von Gesellschafterrechten bei Gesellschaften, in denen eine Beteiligung gehalten wird;

22.8.3 Erwerb, Verkauf und Belastung von Immobilien und ähnlicher Rechte oder Rechte an Immobilien;
22.8.4 Gründung, Verlegung und Schließung von Filialen und Niederlassungen;
22.8.5 Änderung der Geschäftsfelder der Gesellschaft und Aufgabe bestehender und Aufnahme neuer Geschäftsfelder;
22.8.6 Genehmigung des Jahresplans, insbesondere des Haushaltsplans für jedes folgende Jahr;
22.8.7 Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder ähnlichen Verpflichtungen, die einen Gesamtbetrag von zwei-

hunderttausend Euro (EUR 200.000) überschreiten;

22.8.8 Gewährung von Darlehen, die, im Einzelfall, einen Betrag von zweihunderttausend Euro (EUR 200.000) über-

schreiten, allerdings unter Ausschluss von Darlehen zwischen der Gesellschaft und direkten oder indirekten Tochterge-
sellschaften der Gesellschaft;

22.8.9 Abschluss und Kündigung von Kredit- und Darlehensverträgen und anderen Finanzverträgen, die, im Einzelfall,

einen Betrag von zweihunderttausend Euro (EUR 200.000) überschreiten und Änderungen des Kreditrahmens und au-
ßerordentliche Rückzahlungen, allerdings unter Ausschluss von Verträgen zwischen der Gesellschaft und direkten oder
indirekten Tochtergesellschaften der Gesellschaft;

22.8.10 Termingeschäfte über Devisen, Sicherheiten und börsengehandelte Waren und Rechte, sowie weitere Trans-

aktionen mit derivaten Finanzinstrumenten;

22.8.11 Gewährung, Einführung und Änderung von Versorgungsverpflichtungen jeglicher Art;
22.8.12 Abschluss, Änderung oder Auflösung von Arbeitsverträgen, die eine Vergütung von einhundertfünfzigtausend

Euro (EUR 150.000) pro Jahr überschreiten;

22.8.13 Zusicherung oder Gewährung von Sonderzulagen und Gratifikationen jeglicher Art außerhalb bestehender

Arbeitsverträge, sowie Zahlung von Vorschüssen oder Gewährung von Darlehen an Geschäftsführer und Angestellte,
die, im Einzelfall, einen Betrag von fünfzigtausend Euro (EUR 50.000) überschreiten;

22.8.14 Abschluss, Änderung oder Kündigung von Unternehmenstarifverträgen, Betriebsvereinbarungen (von erheb-

licher Bedeutung) und allgemeiner Richtlinien hinsichtlich der betrieblichen Altersvorsorge der Gesellschaft;

22.8.15 Einleitung oder Beendigung von Rechtsstreitigkeiten, insbesondere Schiedsgerichtverfahren mit einem Streit-

wert von über zehntausend Euro (EUR 10.000) im Einzelfall;

22.8.16 Erwerb, Verfügung und/oder Lizenzierung von Nutzungsrechten jeglicher Art hinsichtlich der Rechte an geist-

igem Eigentum, einschließlich Urheberrechte oder sämtliche weiteren Schutzrechte sowie die Weitergabe von Know-
how zur eigenen Verwertung durch die Firma und/oder Drittparteien, sowie die Erteilung oder der Erwerb von Lizenzen
und die Abänderung diesbezüglicher Verträge, jedoch unter Ausschluss von Verfügungen zwischen der Gesellschaft und
direkten und indirekten Tochtergesellschaften der Gesellschaft;

22.8.17 Erteilung einer Vollmacht, durch welche ein Bevollmächtigter einen anderen Bevollmächtigten dazu ermächtigt,

auf Kosten der Gesellschaft einen Vertrag mit diesem zu schließen;

22.8.18 Transaktionen der Gesellschaft und ihrer Investoren mit verbundenen juristischen und natürlichen Personen.

Als direkte oder indirekte Gesellschafter der Gesellschaft werden (einschließlich, zur Klarstellung, European Founders
Fund GmbH („EFF“) und EFF’s direkte und indirekte Gesellschafter (z.B. die Samwer Brüder), aber ausschließlich direkter
oder indirekter Gesellschafter von Holtzbrinck und/oder Access), verbundene Gesellschaften gemäß §§ 15 ff. des deut-
schen Aktiengesetzes (AktG), sowie Angehörige gemäß Abschnitt 15 der deutschen Abgabenordnung (AO) direkter oder
indirekter Gesellschafter angesehen, sofern letztere (mit Ausnahme von EFF und EFF’s direkter und indirekter Gesell-
schafter) - einzeln oder gemeinsam - direkt oder indirekt eine Mehrheitsbeteiligung halten. Die Zustimmungsverpflichtung
gemäß dieses Artikels 22.8.18 ist nicht anwendbar, wenn die Transaktion zum gewöhnlichen Geschäftsgang der Gesell-
schaft gehört und marktüblichen Bedingungen unterliegt;

22.8.19 Änderung der Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft;
22.8.20 Gewährung, Schaffung oder Änderung eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms (einschließlich der Gewährung

jeglicher Aktienoptionen) außerhalb der bestehenden vereinfachten Mitarbeiterbeteiligung, die zwischen den Gesellschaf-
tern in einer Gesellschaftervereinbarung vereinbart wurde;

68577

L

U X E M B O U R G

22.8.21 Ausübung von Stimmrechten und anderen Rechten in einer Gesellschaft, deren Gesellschafter die Gesellschaft

ist, sofern diese Ausübung die Zustimmung der Mehrheit der Investoren nach dieser Satzung erfordert, d.h. gemäß dieses
Artikels 22.8 oder Artikels 17.

22.9 Ist die Zustimmung zum Erwerb, zum Verkauf oder zur Belastung von Objekten wie oben beschrieben erforder-

lich, so ist die Zustimmung ebenfalls für die damit verbundenen vertraglichen Verpflichtungen erforderlich. Die Gesell-
schafterversammlung kann durch einen Beschluss weitere Transaktionen und Maßnahmen bestimmen, die die Zustimmung
der Mehrheit der Investoren erfordern. Die Mehrheit der Investoren kann ihre Zustimmung für bestimmte Gruppen und
Arten von Transaktionen und Maßnahmen auch im Voraus erteilen.

22.10 Die Gesellschafter können durch einen Gesellschafterbeschluss eine Geschäftsordnung für die Geschäftsführer

beschließen.

22.11 Die Geschäftsführung hat sicherzustellen, dass die Bestimmungen dieses Artikels 22, soweit gesetzlich möglich,

auf die gleiche Weise auf sämtliche verbundenen Gesellschaften angewendet werden, in welchen die Gesellschaft direkt
oder indirekt gegenwärtig oder künftig eine Mehrheitsbeteiligung hält.

Art. 23. Protokoll von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer - Protokoll der Entscheidungen des alleinigen Ge-

schäftsführers.

23.1 Das Protokoll einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer wird vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer,

falls vorhanden oder, im Falle seiner Abwesenheit, vom Vorsitzenden pro tempore und dem Schriftführer (falls vorhan-
den), oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unterschied-
liche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der
Kategorie B), werden Protokolle durch einen (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einen (1) Geschäftsführer der
Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsver-
fahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer, falls
vorhanden, oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden solche Kopien oder Auszüge durch einen (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einen (1)
Geschäftsführer der Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet.

23.2 Die Entscheidungen des alleinigen Geschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom alleinigen

Geschäftsführer unterzeichnet wird. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet.

Art. 24. Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Um-

ständen  (i)  durch  die  Unterschrift  des  alleinigen  Geschäftsführers  oder,  für  den  Fall,  dass  die  Gesellschaft  mehrere
Geschäftsführer hat, durch die gemeinsamen Unterschriften zwei (2) beliebiger Geschäftsführer wirksam verpflichtet;
sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäfts-
führer  der  Kategorie  A  und  Geschäftsführer  der  Kategorie  B),  wird  die  Gesellschaft  nur  durch  die  gemeinsamen
Unterschriften mindestens eines (1) Geschäftsführers der Kategorie A und eines (1) Geschäftsführers der Kategorie B
(oder deren Vertreter), oder (ii) durch die gemeinsamen Unterschriften oder die alleinige Unterschrift jedweder Person
(en), der/denen eine Unterschriftsbefugnis durch den Rat der Geschäftsführer übertragen worden ist, wirksam verpflich-
tet.

Art. 25. Beirat.
25.1 Die Gesellschaft hat einen Beirat. Dieser besteht aus sechs (6) stimmberechtigten Mitgliedern. Die Gesellschaf-

terversammlung  kann  durch  einen  Gesellschafterbeschluss  die  Anzahl  der  stimmberechtigten  Mitglieder  des  Beirats
erhöhen oder herabsetzen.

25.2 Die Gesellschafterversammlung kann die Geschäftsordnung des Beirats nur durch einen einstimmigen Gesell-

schafterbeschluss festlegen und/oder verändern.

25.3 Die stimmberechtigten Mitglieder des Beirats werden von dem ernennenden Gesellschafter jedes entsprechenden

Mitglieds durch schriftliche Mitteilung an die Gesellschaft wie folgt ernannt, abberufen oder ersetzt:

25.3.1 Vier (4) stimmberechtigte Mitglieder des Beirats werden von dem Gesellschafter Rocket nach eigenem Ermessen

ernannt;

25.3.2 Ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats wird von dem Gesellschafter Holtzbrinck nach eigenem Ermessen

ernannt; und

25.3.3 Ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats wird von dem Gesellschafter Access nach eigenem Ermessen

ernannt.

25.4 Der Beirat kann nicht-stimmberechtigte Mitglieder als Beobachter haben.
25.5 Der Beirat hat einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden. Ein von Rocket ernanntes stimm-

berechtigtes  Mitglied  ist  der  Vorsitzende  des  Beirats.  Die  Geschäftsordnung  des  Beirats  hat  weitere  Bestimmungen,
insbesondere  hinsichtlich  der  Selbstorganisation  des  Beirats,  zu  enthalten.  Der  Beirat  fasst  Beschlüsse  mit  einfacher
Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Der Beirat hält regelmäßig Sitzungen ab, mindestens einmal pro Kalenderquartal.

68578

L

U X E M B O U R G

25.6 Der Beirat ist für die Beratung der Geschäftsführer der Gesellschaft hinsichtlich Strategie und operativer Ange-

legenheiten zuständig und berät mit den Geschäftsführern über den Haushalt der Gesellschaft.

25.7 Der Beirat ist kein Aufsichtsrat im Sinne des Artikels 60bis-11 ff. des Gesetzes von 1915.

E. Aufsicht und Prüfung der Gesellschaft

Art. 26. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
26.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der

Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)). Die Gesellschafterversammlung
ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.

26.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
26.3 Die Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Recht der permanenten Überprüfung und Kontrolle aller Ge-

schäfte der Gesellschaft.

26.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember

2002  betreffend  das  Handelsregister  und  die  Buchhaltung  und  den  Jahresabschluss  von  Unternehmen,  in  der  jeweils
gültigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d’entreprises agréé(s)) ernennen, entfällt
die Funktion des Rechnungsprüfers.

26.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die

Gesellschafterversammlung abberufen werden.

F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinnverwendung - Abschlagsdividenden

Art. 27. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am

einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

Art. 28. Jahresabschluss und Gewinne.
28.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Rat der Geschäftsführer erstellt im

Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und
Verlustrechnung.

28.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage

der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.

28.3  Durch  einen  Gesellschafter  erbrachte  Einlagen  in  Rücklagen  können  mit  Zustimmung  dieses  Gesellschafters

ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.

28.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage der Gesellschaft verhältnis-

mäßig herabgesetzt werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.

28.5 Auf Vorschlag des Rates der Geschäftsführer bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den Be-

stimmungen des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung, wie der verbleibende jährliche Nettogewinn der Gesellschaft
verwendet werden soll.

28.6 Vorbehaltlich des Artikels 8 erfolgen Ausschüttungen an die Gesellschafter proportional zur Anzahl der von ihnen

an der Gesellschaft gehaltenen Anteile.

Art. 29. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
29.1 Der Rat der Geschäftsführer kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche

vom Rat der Geschäftsführer vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur
Verfügung stehen. Der ausschüttbare Betrag wird gegebenenfalls im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 8 verteilt
und darf nicht die Summe der seit dem Ende des vergangenen Geschäftsjahres angefallenen Gewinne, gegebenenfalls
erhöht  durch  vorgetragene  Gewinne  und  ausschüttbare  Rücklagen,  beziehungsweise  vermindert  durch  vorgetragene
Verluste und Summen, die einer Rücklage zugeführt werden, welche nach dieser Satzung oder dem Gesetz von 1915 nicht
ausgeschüttet werden darf, übersteigen.

29.2 Das Agio, andere Kapitalreserven und andere ausschüttbare Rücklagen können im Einklang mit den Bestimmungen

des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

G. Liquidation

Art. 30. Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Ab-

wicklung durch einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden,
die über die Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit
nichts anderes bestimmt wird, haben die Liquidatoren die weitestgehenden Befugnisse für die Verwertung der Vermö-
genswerte und die Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

68579

L

U X E M B O U R G

H. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht

Art. 31. Anwendbares Recht.
31.1 Sämtliche in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten unterliegen den Bestimmungen des Gesetzes von

1915 und jeder Gesellschaftervereinbarung, die die Gesellschafter in der Zwischenzeit mit der Gesellschaft eingehen und
durch die bestimmte Bestimmungen dieser Satzung ergänzt werden könnten. Sollte ein Artikel dieser Satzung mit den
Bestimmungen einer Gesellschaftervereinbarung in Widerspruch stehen, so ist die Gesellschaftervereinbarung zwischen
den Parteien, soweit nach luxemburgischem Recht zulässig, maßgebend.

31.2 Diese Satzung wurde auf Englisch verfasst, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; im Falle von Abweichungen

zwischen der englischen und der deutschen Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.“

5. Verschiedenes.

Nach ordnungsgemäßer Beratung über jeden Tagesordnungspunkt fasst die Gesellschafterversammlung einstimmig die

folgenden Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, (i) Holtzbrinck und (ii) Access, vorbenannt, als neue Gesellschafter der

Gesellschaft anzunehmen.

<i>Zweiter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, das Gesellschaftskapital der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von

siebzehntausendsiebenhundertfünfzig Euro (EUR 17.750) um einen Betrag von siebentausendzweihundertfünfzig Euro
(EUR 7.250) auf einen Betrag von fünfundzwanzigtausend Euro (EUR 25.000) durch die Ausgabe von siebentausendzwei-
hundertfünfzig (7.250) Anteilen der Serie A mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Anteil, zu erhöhen.

<i>Zeichnung

Die neuen Anteile der Serie A wurden ordnungsgemäß wie folgt gezeichnet:
- dreitausendsechshundertfünfundzwanzig (3.625) Anteile der Serie A wurden von Holtzbrinck, vorbenannt, hier ver-

treten wie vorerwähnt, zu einem Preis von dreitausendsechshundertfünfundzwanzig Euro (EUR 3.625) gezeichnet; und

- dreitausendsechshundertfünfundzwanzig (3.625) Anteile der Serie A wurden von Access, vorbenannt, hier vertreten

wie vorerwähnt zu einem Preis von dreitausendsechshundertfünfundzwanzig Euro (EUR 3.625) gezeichnet.

<i>Zahlung

Die von Holtzbrinck, vorbenannt, gezeichneten dreitausendsechshundertfünfundzwanzig (3.625) Anteile der Serie A

wurden vollständig eingezahlt durch eine Bareinlage in Höhe von dreitausendsechshundertfünfundzwanzig Euro (EUR
3.625).

Die von Access, vorbenannt, gezeichneten dreitausendsechshundertfünfundzwanzig (3.625) Anteile der Serie A wurden

vollständig eingezahlt durch eine Bareinlage in Höhe von dreitausendsechshundertfünfundzwanzig Euro (EUR 3.625).

Die Summe von sieben tausend zweihundertfünfzig Euro (EUR 7.250,-) steht der Gesellschaft ab sofort zur freien

Verfügung, so wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde.

Die Einlage in Höhe von siebentausendzweihundertfünfzig Euro (EUR 7.250) wird vollständig dem Gesellschaftskapital

zugeführt.

<i>Dritter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, Artikel fünf (5) der Satzung der Gesellschaft zu ändern, welcher nunmehr

wie folgt lautet:

„ Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt fünfundzwanzigtausend Euro (EUR 25.000), bestehend aus:
5.1.1 zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteilen mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Anteil

(die „Stammanteile”), und

5.1.2 zwölftausendfünfhundert (12.500) Anteilen der Serie A mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro

Anteil (die „Anteile der Serie A”, die auch als „Vorzugsanteile“ bezeichnet werden).

Die mit den Anteilen verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es wird in dieser Satzung oder

durch das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.

5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-

zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.

5.3 Jede der Gesellschaften (i) Global Fin Tech Holding S.à r.l. („Rocket“), (ii) HV Holtzbrinck Ventures Fund V GmbH

&amp; Co. KG („Holtzbrinck“) und (iii) Al Lendico Holdings LLC („Access“; Rocket, Holtzbrinck und Access gemeinschaftlich
die „Investoren“ und jeweils ein „Investor“) ist zur Zeichnung einer Anzahl weiterer bei einer Kapitalerhöhung ausgege-
benen Anteile berechtigt, wodurch ein Investmentangebot eines Dritten umgesetzt wird (bei dem es sich weder um einen

68580

L

U X E M B O U R G

Gesellschafter, noch um eine mit einem Gesellschafter verbundene Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. des deutschen
Aktiengesetzes (AktG) (ein „Drittinvestor“) handelt), und der vom Beirat zugestimmt wurde (eine „Investition eines
Dritten“) - unabhängig davon, ob diese vom Drittinvestor oder von einem oder mehreren vergleichbaren Gesellschaftern
erfolgte - die zur Erhaltung der Beteiligungsquote an der Gesellschaft vor einer solchen Kapitalerhöhung erforderlich ist,
und dies zu denselben Bedingungen, wie bei einer Investition eines Dritten. Der jeweilige Investor hat die Gesellschaft
durch eine verbindliche Erklärung innerhalb von drei (3) Wochen darüber zu unterrichten, ob er sein Recht gemäß des
vorstehenden Satzes dieses Artikels 5.3 ausüben möchte.“

<i>Vierter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, unter anderem infolge des Vorstehenden, die gänzliche Neufassung der

Satzung der Gesellschaft, welche nunmehr wie in der Tagesordnung der vorliegenden Urkunde dargestellt lautet.

Da die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung geschlossen.

<i>Kosten und Auslagen

Die Kosten, Auslagen, Honorare und Gebühren jeglicher Art, die von der Gesellschaft zu tragen sind, werden auf

ungefähr EUR 3.200,- geschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg am eingangs erwähnten Datum.
Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache beherrscht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende

Urkunde auf Verlangen der erschienenen Parteien auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung;
auf Verlangen besagter erschienener Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen
Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.

Die vorstehende Urkunde ist der Bevollmächtigten der erschienenen Parteien, welche dem Notar mit Namen, Vorn-

amen und Wohnsitz bekannt ist, verlesen und vom Notar gemeinsam mit dieser Bevollmächtigten unterzeichnet worden.

Gezeichnet: X. TANG und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 31 mars 2014. Relation: LAC/2014/14879. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Begehr erteilt.

Luxemburg, den 12. Mai 2014.

Référence de publication: 2014066558/1289.
(140077916) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2014.

Mizzen Topco S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Capital social: GBP 2.159.575,52.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 19, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 171.038.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-fourth day of January.
Before the undersigned Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held

an extraordinary general meeting of the shareholders of Mizzen Topco S.C.A., a société en commandite par actions

incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at at 15, rue
Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Com-
panies’ Register under number B 171038, incorporated pursuant to a deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in
Luxembourg, on 10 August 2012, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 21 September
2012 no. 2357, last amended on 10 May 2013 pursuant to a deed of Maître Carlo Wersandt, notary residing in Luxem-
bourg, published with the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations no. 1849 of 31 July 2013 (the “Company”).

The meeting was opened at 12 a.m. CET with Ms. Christine Kröger, residing in Luxembourg, in the chair,
who appointed as secretary Ms. Ikrame Dabaj, professionally residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mr. Georg Gerstberger, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1. Reduction of the Company’s share capital by an amount of eight thousand five hundred twenty-four pounds sterling

and fifty-nine pence (GBP 8,524.59), through the cancellation of two hundred and eighty-four thousand one hundred and
fifty-three (284,153) class B1 shares, two hundred and eighty-four thousand one hundred and fifty-three (284,153) class

68581

L

U X E M B O U R G

B2 shares and two hundred and eighty-four thousand one hundred and fifty-three (284,153) class B3 shares held by Mizzen
Manco S.C.A. in the Company; and

2. Restatement of article 6.1.1 of the Company’s articles of association to reflect the above.
II. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their

shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the represented
shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to this deed to be filed at the same time with the
registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, initialled “ne varietur” by the appearing parties will also remain annexed

to this deed.

III. That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and the shareholders present

or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no
convening notices were necessary.

IV. That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deli-

berate on all the items of the agenda.

The general meeting has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting resolves to reduce, within the scope of article 49-3 of the of the law of August 10, 1915 on

commercial companies, as amended (the “Law”), the share capital of the Company by an amount of eight thousand five
hundred  twenty-four  pounds  sterling  and  fifty-nine  pence  (GBP  8,524.59),  in  order  to  bring  the  share  capital  of  the
Company from its present amount of two million one hundred fifty-nine thousand five hundred seventy-five pounds
sterling and fifty-two pence (GBP 2,159,575.52) to a new amount of two million one hundred fifty-one thousand fifty
pounds sterling and ninety-three pence (GBP 2,151,050.93), by way of cancellation by the Company of two hundred and
eighty-four thousand one hundred and fifty-three (284,153) class B1 shares, two hundred and eighty-four thousand one
hundred and fifty-three (284,153) class B2 shares and two hundred and eighty-four thousand one hundred and fifty-three
(284,153) class B3 shares held by Mizzen Manco S.C.A. (the “Cancelled Shares”). The counter value of the Cancelled
Shares shall be paid out to Mizzen Manco S.C.A. and the general meeting therefore grants power to the general partner
of the Company to proceed with the payment of the counter-value in the aggregate amount of eight thousand five hundred
twenty-four pounds sterling and fifty-nine pence (GBP 8,524.59) to Mizzen Manco S.C.A., but not before a period of thirty
days from the publication of the present deed in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, under observance
of the provisions of Article 69 of the Law.

<i>Second resolution

The general meeting resolves to restate article 6.1.1 of the Company’s articles of association, which shall henceforth

read as follows:

“ Art. 6. Share capital.
6.1 Issued share capital
6.1.1 The Company’s issued share capital is set at two million one hundred fifty-one thousand fifty pounds sterling and

ninety-three pence (GBP 2,151,050.93), consisting of the following shares:

(a) sixty-two million two hundred forty-seven thousand five hundred eighty-two (62,247,582) Class A1 shares having

a nominal value of one penny (GBP 0.01) per share;

(b) sixty-two million two hundred forty-seven thousand five hundred seventy-seven (62,247,577) Class A2 shares

having a nominal value of one penny (GBP 0.01) per share;

(c) sixty-two million two hundred forty-seven thousand five hundred seventy-three (62,247,573) Class A3 shares having

a nominal value of one penny (GBP 0.01) per share;

(d) nine million ninety-eight thousand nine hundred and thirty-three (9,098,933) Class B1 shares having a nominal value

of one penny (GBP 0.01) per share;

(e) nine million ninety-eight thousand nine hundred and twenty-eight (9,098,928) Class B2 shares having a nominal

value of one penny (GBP 0.01) per share;

(f) nine million ninety-eight thousand nine hundred and twenty-eight (9,098,926) Class B3 shares having a nominal value

of one penny (GBP 0.01) per share;

(g) three hundred fifty-five thousand one hundred ninety-two (355,192) Class C1 shares having a nominal value of one

penny (GBP 0.01) per share;

(h) three hundred fifty-five thousand one hundred ninety-one (355.191) Class C2 shares having a nominal value of one

penny (GBP 0.01) per share; and

(i) three hundred fifty-five thousand one hundred ninety-one (355,191) Class C3 shares having a nominal value of one

penny (GBP 0.01) per share.”

68582

L

U X E M B O U R G

<i>Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are

estimated at EUR 2,000.-.

There being no further business the meeting is closed at 12:15 a.m. CET.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French translation. On express request of the same appearing
person, and in case any divergences would arise between the French and the English text, the English text will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by surname, name and residence, said

person signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L’an deux mille quatorze, le vingt-quatrième jour du mois de janvier.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S’est déroulée

une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Mizzen Topco S.C.A., une société en commandite par

actions, constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg et ayant son siège social sis 15, rue Edward
Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 171038, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire résidant à Lu-
xembourg, en date du 10 août 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 21 septembre 2012
sous le numéro 2356. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois le 10 mai 2013 par acte de Maître Carlo Wersandt,
notaire résidant à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 31 juillet 2013 sous le
numéro 1849 (la «Société»).

L’assemblée a été ouverte à 12 heures sous la présidence de Mademoiselle Christine Kröger, résidant à Luxembourg,
laquelle a désigné comme secrétaire Mademoiselle Ikrame Dabaj, résidant professionnellement à Luxembourg.
L’assemblée a élu comme scrutateur Monsieur Georg Gerstberger, résidant à Luxembourg.
L’assemblée ayant été constituée, la présidente a déclaré et prié le notaire instrumentant d’acter:
I. Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. Réduction du capital social de la Société d’un montant de huit mille cinq cent vingt-quatre livres sterling et cinquante-

neuf pence (GBP 8.524,59) par l’annulation de deux cent quatre-vingt-quatre mille cent cinquante-trois (284.153) actions
de catégorie B1, deux cent quatre-vingt-quatre mille cent cinquante-trois (284.153) actions de catégorie B2 et deux cent
quatre-vingt-quatre mille cent cinquante-trois (284.153) actions de catégorie B3 détenues par Mizzen Manco S.C.A. dans
la Société; et

2. Modification de l’article 6.1.1. des statuts de la Société;
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu'ils détiennent figurent sur une feuille de présence; cette feuille de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, signées «ne varietur», par les personnes comparantes resteront atta-

chées à cet acte.

III. Que l’intégralité du capital social est présente ou représentée à la présente assemblée et les actionnaires présents

ou représentés déclarent avoir reçu notification et avoir pris connaissance de l’ordre du jour avant la tenue de cette
assemblée, aucune convocation n’a été nécessaire.

IV. Que la présente assemblée, représentant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement sur les points portés à l’ordre du jour.

L’assemblée générale a demandé au notaire d’acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale des actionnaires décide de réduire, en application de l’article 49-3 de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), le capital social de la Société d’un montant de huit mille cinq cent
vingt-quatre livres sterling et cinquante-neuf pence (GBP 8.524,59) afin de le réduire de son montant actuel de deux
millions cent cinquante-neuf mille cinq cent soixante-quinze livres sterling et cinquante-deux pence (GBP 2.159.575,52)
à un nouveau montant de deux millions cent cinquante et un mille cinquante livres sterling et quatre-vingt-treize pence
(GBP 2.151.050,93) par l’annulation par la Société de deux cent quatre-vingt-quatre mille cent cinquante-trois (284.153)
actions de catégorie B1, deux cent quatre-vingt-quatre mille cent cinquante-trois (284.153) actions de catégorie B2 et
deux cent quatre-vingt-quatre mille cent cinquante-trois (284.153) actions de catégorie B3 détenues par Mizzen Manco

68583

L

U X E M B O U R G

S.C.A. (les «Actions Annulées»). La contre-valeur des Actions Annulées sera versée à Mizzen Manco S.C.A. et l’assemblée
générale donne de ce fait procuration à l’associé commandité de la Société de procéder au paiement de la contre-valeur
d’un montant total de huit mille cinq cent vingt-quatre livres sterling et cinquante-neuf pence (GBP 8.524,59) à Mizzen
Manco S.C.A., ce paiement ne devant pas intervenir avant un délai de trente jours à compter de la publication du présent
acte au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, conformément aux dispositions de l’Article 69 de la Loi.

<i>Deuxième Résolution

L’assemblée générale des actionnaires décide de modifier l’article 6.1.1 des statuts de la Société dans ces termes:

« Art. 6. Capital Social.
6.1 Capital souscrit
6.1.1 Le capital souscrit de la Société est établi à deux millions cent cinquante et un mille cinquante livres sterling et

quatre-vingt-treize pence (GBP 2.151.050,93), composé comme suit:

(a) soixante-deux millions deux cent quarante-sept mille cinq cent quatre-vingt-deux (62.247.582) actions de catégorie

A1 ayant une valeur nominale d’un Penny (GBP 0,01) chacune;

(b) soixante-deux millions deux cent quarante-sept mille cinq cent soixante-dix-sept (62.247.577) actions de catégorie

A2 ayant une valeur nominale d’un Penny (GBP 0,01) chacune;

(c) soixante-deux millions deux cent quarante-sept mille cinq cent soixante-treize (62.247.573) actions de catégorie

A3 ayant une valeur nominale d’un Penny (GBP 0,01) chacune;

(d) neuf millions quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent trente-trois (9.098.933) actions de catégorie B1 ayant une valeur

nominale d’un Penny (GBP 0,01) chacune;

(e) neuf millions quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent vingt-huit (9.098.928) actions de catégorie B2 ayant une valeur

nominale d’un Penny (GBP 0,01) chacune;

(f) neuf millions quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent vingt-six (9.098.926) actions de catégorie B3 ayant une valeur

nominale d’un Penny (GBP 0,01) chacune;

(g) trois cent cinquante-cinq mille cent quatre-vingt-douze (355.192) actions de catégorie C1 ayant une valeur nominale

d’un Penny (GBP 0,01) chacune;

(h) trois cent cinquante-cinq mille cent quatre-vingt-onze (355.191) actions de catégorie C2 ayant une valeur nominale

d’un Penny (GBP 0,01) chacune;

(i) trois cent cinquante-cinq mille cent quatre-vingt-onze (355.191) actions de catégorie C3 ayant une valeur nominale

d’un Penny (GBP 0,01) chacune.»

<i>Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incomberont à la Société sont

estimés à EUR 2.000,-

Ne restant plus de points à l’ordre du jour, l’assemblée est close à 12:15 heures.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, à la date indiquée au début de ce document.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par son prénom, nom

et lieu de résidence, ledit comparant a signé avec Nous, le notaire, le présent acte.

Signé: C. KRÖGER, I. DABAJ, G. GERSTBERGER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 février 2014. Relation: LAC/2014/5124. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 8 avril 2014.

Référence de publication: 2014050648/180.
(140057775) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2014.

CWICCS S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1135 Luxembourg, 4, avenue des Archiducs.

R.C.S. Luxembourg B 185.792.

STATUTS

L'an deux mille quatorze, le vingt mars.
Par-devant Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Luxembourg.

68584

L

U X E M B O U R G

A comparu:

Monsieur Claude Wilwers, titulaire d’un diplôme HEC, demeurant à L-1135 Luxembourg, 4, avenue des Archiducs.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité

limitée unipersonnelle qu'il va constituer:

Titre I 

er

 . Dénomination - Siège social - Objet - Durée - Capital social

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les

dispositions légales en vigueur et notamment celles de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi
que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet le conseil et la représentation économique et commerciale. La société a également pour

objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères,
l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre
manière,  de  valeurs  mobilières  de  toutes  espèces,  la  gestion  ou  la  mise  en  valeur  du  portefeuille  qu'elle  possédera,
l’acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées. La société peut prêter ou emprunter
avec ou sans garantie aux sociétés faisant partie de son groupe, elle peut participer à la création et au développement de
toutes sociétés et leur prêter tous concours. D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de
surveillance et de documentation et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement
de son objet.

Elle pourra d’une façon générale, faire tous actes, transactions ou opérations commerciales, industrielles, financières,

mobilières et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en
faciliter ou développer la réalisation.

Art. 3. La société prend la dénomination de CWICCS S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de

Luxembourg par simple décision des associés. La société peut ouvrir des agences ou des succursales dans toutes les autres
localités du pays et à l’étranger.

Art. 5. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de 12.500,- Euros (douze mille cinq cents euros), représenté par 500 (cinq

cents) parts sociales d'une valeur nominale de 25,- Euros (vingt-cinq euros) chacune.

Titre II. Administration. Assemblée Générale

Art. 7. La société est administrée et gérée par un ou plusieurs gérants nommés et révoqués par l’associé unique ou,

selon le cas, les associés, le(s)quel(s) fixe(ent) la durée de leur mandat.

Les pouvoirs du (ou des) gérant(s) seront déterminés dans leur acte de nomination.
Le ou les gérants peuvent à tout moment être révoqués par les associés.
A défaut de disposition contraire, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au

nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement
de son objet social.

Art. 8. L’associé unique exerce les pouvoirs attribués à l’assemblée des associés. Les décisions de l’associé unique

prises dans le domaine visé à l’alinéa 1 

er

 sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal  ou  établis  par  écrit,  Cette  disposition  n’est  applicable  aux  opérations  courantes  conclues  dans  les  conditions
normales.

Art. 9. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par lui (eux) au nom de la société.

Titre III. Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 10. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 11. Chaque année, à la clôture de l’exercice, les comptes de la société sont arrêtés et la gérance dresse les comptes

sociaux, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Art. 12. L’associé ou les associés peut/peuvent prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et

du bilan.

Art. 13. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugées

nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition des associés.

68585

L

U X E M B O U R G

Titre IV. Dissolution - Liquidation

Art. 14. La société n'est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

Art. 15. Les créanciers personnels, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit,

faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 16. En cas de dissolution de la société, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés, qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Disposition Générale

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions légales en vigueur régissant les sociétés à responsabilité limitée.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice commence le jour de la constitution et finira le trente et un décembre deux mille quatorze.

<i>Souscription - Libération

Les statuts ayant été ainsi arrêtés, toutes les parts sociales ont été souscrites par Monsieur Claude Wilwers, prénommé.
Le souscripteur a entièrement libéré ses parts par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille

cinq cents Euros (EUR 12.500,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au
notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Evaluation des Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s'élèvent approximativement à la somme de neuf cents euros
(EUR 900,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

L’associé unique a immédiatement pris les décisions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi à L-1135 Luxembourg, 4, avenue des Archiducs.
2. La personne suivante est nommée comme gérant unique de la Société pour une durée indéterminée:
Monsieur Claude Wilwers, titulaire d’un diplôme HEC, né à Luxembourg le 13 mai 1965, demeurant à L-1135 Lu-

xembourg, 4, avenue des Archiducs.

L’attention du comparant a été expressément attirée par le notaire instrumentaire sur la nécessité d’obtenir des

autorités compétentes les autorisations et/ou agréments requis le cas échéant afin d’exercer les activités telles que dé-
crites à l’article 2 des présents Statuts.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête les présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Wilwers, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 24 mars 2014. Relation: LAC/2014/13539. Reçu soixante-quinze euros (75,00

€).

<i>Le Receveur (signé): Irène Thill.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Luxembourg, le 3 avril 2014.

Référence de publication: 2014048503/99.
(140055208) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2014.

GreenTech, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-4972 Dippach, 2, route des 3 Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 187.173.

STATUTS

L'an deux mille quatorze, le neuf mai.
Par-devant Nous Maître Jean-Paul MEYERS, notaire de résidence à RAMBROUCH, Grand-Duché du Luxembourg.

A COMPARU:

68586

L

U X E M B O U R G

Monsieur Pierre STREMLER, né le 10 mars 1980 à Thionville (France), commerçant, demeurant professionnellement

à L-4972 Dippach, 2, route des 3 Cantons.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser l'acte de constitution d'une société à responsabilité

limitée qu'il souhaite constituer avec les statuts suivants:

Chapitre I 

er

 . Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1 

er

 . Forme, Dénomination.  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée (la «Société») régie

par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, (les «Lois»), et par les présents statuts (les «Statuts»).

La Société peut comporter un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales ou plusieurs associés, dans

la limite de quarante (40) associés.

La Société adopte la dénomination «GreenTech».

Art. 2. Siège Social. Le siège social de la Société est établi dans la commune de Dippach, Grand-Duché de Luxembourg.
Le siège social peut être transféré à tout autre endroit de la commune de Luxembourg par une décision des Gérants.
Des succursales ou d'autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché du Luxembourg ou à l'étranger par

décision des Gérants.

Dans l'hypothèse où les Gérants estiment que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social

sont de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social ou la communication aisée avec ce siège
ou entre ce siège et l'étranger ou que de tels événements se sont produits ou sont imminents, la Société pourra transférer
provisoirement  le  siège  social  à  l'étranger  jusqu'à  cessation  complète  de  ces  circonstances  anormales.  Ces  mesures
provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège,
demeurera régie par les Lois. Ces mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par
les Gérants.

Art. 3. Objet. La Société a pour objet l'exploitation d'une société d'import et d'export, d'achat et de vente, de location,

d'e-commerce, d'atelier de réparation de machines, de robots, d'équipements et de matériaux, notamment de jardinage,
d'entretien d'espaces verts ainsi que de divers articles de loisirs.

D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations,

financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles, qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au
développement de son objet.

La Société a en outre pour objet la mise en valeur de propriétés intellectuelles, sous toutes formes, ainsi que la mise

en valeur de biens immobiliers pour son propre compte.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute, à tout moment, par une résolution des associés, statuant aux conditions de quorum et de

majorité requises par les Lois ou par les Statuts, selon le cas, conformément à l'article 29 des Statuts.

Chapitre II. Capital, Parts sociales

Art. 5. Capital Émis. Le capital émis de la Société est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500,- €) divisé en cent

(100) parts sociales ayant une valeur nominale de cent vingt-cinq Euros (125,- €) chacune, celles-ci étant entièrement
libérées.

Les droits et obligations inhérents aux parts sociales sont identiques sauf stipulation contraire des Statuts ou des Lois.

Art. 6. Parts Sociales. Chaque part sociale donne droit à une voix.
Chaque part sociale est indivisible à l'égard de la Société.
Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un représentant commun désigné

ou non parmi eux.

Lorsque la Société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut librement céder ses parts sociales.
Lorsque la Société compte plusieurs associés, les parts sociales sont librement cessibles entre eux et les parts sociales

ne peuvent être cédées à des non-associés qu'avec l'autorisation des associés représentant au moins trois quart du capital
social.

La cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou par un acte sous seing privé. Une telle cession

n'est opposable à la Société et aux tiers qu'après avoir été dûment notifiée ou acceptée par elle conformément à l'article
1690 du Code civil luxembourgeois.

La Société peut acquérir ses propres parts sociales en vue de leur annulation immédiate.
La propriété d'une part sociale emporte de plein droit acceptation des Statuts de la Société et des décisions valablement

adoptées par les associés.

Art. 7. Augmentation et Réduction du Capital. Le capital émis de la Société peut être augmenté ou réduit, en une ou

plusieurs fois, par une résolution des associés adoptée aux conditions de quorum et de majorité requises par les Statuts
ou, le cas échéant, par les Lois pour toute modification des Statuts.

68587

L

U X E M B O U R G

Art. 8. Incapacité, Faillite ou Insolvabilité d'un Associé. L'incapacité, la faillite, l'insolvabilité ou tout autre événement

similaire affectant les associés n'entraîne pas la mise en liquidation de la Société.

Chapitre III. Gérants, Commissaires aux comptes

Art. 9. Gérants. La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants qui n'ont pas besoin d'être associés

(les «Gérants»).

Si deux (2) Gérants sont nommés, ils géreront conjointement la Société.
Si plus de deux (2) Gérants sont nommés, ils formeront un conseil de gérance (le «Conseil de Gérance»).
Les Gérants seront nommés par les associés, qui détermineront leur nombre et la durée de leur mandat. Les Gérants

peuvent être renommés et peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par une résolution des associés.

Les associés ne participeront ni ne s'immisceront dans la gestion de la Société.

Art. 10. Pouvoirs des Gérants. Les Gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes

nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la Société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par les Statuts ou par les Lois aux associés relèvent de la

compétence des Gérants.

Art. 11. Délégation de Pouvoirs - Représentation de la Société. Les Gérants peuvent déléguer des pouvoirs ou des

mandats spéciaux, ou confier des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou des comités de leur choix.

La Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature individuelle du Gérant unique ou par la signature conjointe

de deux Gérants si plus d'un Gérant a été nommé.

La Société sera également engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toute

personne à qui ce pouvoir de signature aura été délégué par les Gérants, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 12. Réunions du Conseil de Gérance. Dans l'hypothèse où un Conseil de Gérance est formé, les règles suivantes

s'appliqueront:

Le Conseil de Gérance peut nommer parmi ses membres un président (le «Président»). Il peut également nommer un

secrétaire qui n'a pas besoin d'être lui-même Gérant et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux du Conseil
de Gérance (le «Secrétaire»).

Le Conseil de Gérance se réunira sur convocation du Président. Une réunion du Conseil de Gérance doit être con-

voquée si deux (2) de ses membres le demandent.

Le Président présidera toutes les réunions du Conseil de Gérance, mais en son absence le Conseil de Gérance désignera

un autre membre du Conseil de Gérance comme président pro tempore par un vote à la majorité des Gérants présents
ou représentés à cette réunion.

Sauf en cas d'urgence ou avec l'accord préalable de tous ceux qui ont le droit d'y assister, une convocation écrite devra

être transmise, trois (3) jours calendaires au moins avant la date prévue pour la réunion du Conseil de Gérance, par tout
moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit. La convocation indiquera la date, l'heure et le lieu
de la réunion ainsi que l'ordre du jour et la nature des affaires à traiter. Il pourra être renoncé à cette convocation par
un accord correctement consigné de chaque membre du Conseil de Gérance. Aucune convocation spéciale ne sera
requise pour les réunions se tenant à des dates et des lieux déterminés préalablement par une résolution adoptée par le
Conseil de Gérance.

Les réunions du Conseil de Gérance se tiendront à Luxembourg ou à tout autre endroit que le Conseil de Gérance

pourra déterminer de temps à autre.

Tout Gérant peut se faire représenter aux réunions du Conseil de Gérance en désignant par un écrit, transmis par

tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit, un autre Gérant comme son mandataire. Tout
Gérant peut représenter un ou plusieurs membres du Conseil de Gérance.

Le Conseil de Gérance ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié (1/2) des Gérants en fonction est

présente ou représentée.

Les décisions seront prises à la majorité des voix des Gérants présents ou représentés à cette réunion.
Un ou plusieurs Gérants peuvent prendre part à une réunion par conférence téléphonique, visioconférence ou tout

autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer simulta-
nément les unes avec les autres. Une telle participation sera considérée équivalente à une présence physique à la réunion.

Une décision écrite, signée par tous les Gérants, est régulière et valable de la même manière que si elle avait été

adoptée à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être consignée
dans un seul ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu et signé par un ou plusieurs Gérants.

Art. 13. Résolutions des Gérants. Les résolutions des Gérants doivent être consignées par écrit.
Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance seront signés par le Président de la réunion et par le Secrétaire

(s'il y en a). Les procurations y resteront annexées.

Les copies ou les extraits des résolutions écrites ou les procès-verbaux, destinés à être produits en justice ou ailleurs,

pourront être signés par le Gérant unique ou par deux Gérants agissant conjointement si plus d'un Gérant a été nommé.

68588

L

U X E M B O U R G

Art. 14. Rémunération et Dépenses. Sous réserve de l'approbation des associés, les Gérants peuvent recevoir une

rémunération pour leur gestion de la Société et peuvent, de plus, être remboursés de toutes les dépenses qu'ils auront
exposées en relation avec la gestion de la Société ou la poursuite de l'objet social de la Société.

Art. 15. Conflits d'Intérêt. Si un ou plusieurs Gérants a ou pourrait avoir un intérêt personnel dans une transaction

de la Société, ce Gérant devra en aviser les autres Gérants et il ne pourra ni prendre part aux délibérations ni émettre
un vote sur une telle transaction.

Dans l'hypothèse d'un Gérant unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues

entre la Société et son Gérant ayant un intérêt opposé à celui de la Société.

Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque (i) l'opération en question est conclue à des

conditions normales et (ii) si elle tombe dans le cadre des opérations courantes de la Société.

Aucun contrat ni autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou entreprises ne sera affecté ou invalidé par

le simple fait qu'un ou plusieurs Gérants ou tout fondé de pouvoir de la Société y a un intérêt personnel, ou est gérant,
collaborateur, membre, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou entreprise. Toute personne liée de
la manière décrite ci-dessus, à une société ou entreprise, avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en
relations d'affaires, ne devra pas en raison de cette affiliation à cette société ou entreprise, être automatiquement em-
pêchée de délibérer, de voter ou d'agir autrement sur une opération relative à de tels contrats ou transactions.

Art. 16. Responsabilité des Gérants - Indemnisation. Les Gérants n'engagent pas leur responsabilité personnelle lors-

que, dans l'exercice de leurs fonctions, ils prennent des engagements pour le compte de la Société.

Les Gérants sont uniquement responsables de l'accomplissement de leurs devoirs.
La Société indemnisera tout membre du Conseil de Gérance, fondé de pouvoir ou employé de la Société et, le cas

échéant, leurs successeurs, leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour tous dommages
qu'ils ont à payer et tous frais raisonnables qu'ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que défendeurs
dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs fonctions
actuelles ou anciennes de Gérant(s), de fondé de pouvoir ou d'employé de la Société, ou à la demande de la Société, de
toute autre société dans laquelle la Société est actionnaire ou créancier et dans laquelle ils n'ont pas droit à indemnisation,
exception faite des cas où leur responsabilité est engagée pour négligence grave ou mauvaise gestion. En cas d'arrangement
transactionnel, l'indemnisation ne portera que sur les questions couvertes par l'arrangement transactionnel et dans ce
cas seulement si la Société reçoit confirmation par son conseiller juridique que la personne à indemniser n'est pas coupable
de négligence grave ou mauvaise gestion. Ce droit à indemnisation n'est pas exclusif d'autres droits auxquels les personnes
susnommées pourraient prétendre en vertu des Statuts.

Art. 17. Commissaires aux Comptes. Sauf lorsque, conformément aux Lois, les comptes annuels et/ou les comptes

consolidés de la Société doivent être vérifiés par un réviseur d'entreprises indépendant, les affaires de la Société et sa
situation financière, en particulier ses documents comptables, peuvent et devront, dans les cas prévus par la loi, être
contrôlés par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas besoin d'être eux-mêmes associés.

Le(s) commissaire(s) aux compte(s) ou réviseur(s) d'entreprises indépendant(s) seront, le cas échéant, nommés par

les Associés qui détermineront leur nombre et la durée de leur mandat. Leur mandat peut être renouvelé. Ils peuvent
être  révoqués  à  tout  moment,  avec  ou  sans  motif,  par  une  résolution  des  associés  sauf  dans  les  cas  où  le  réviseur
d'entreprises indépendant peut seulement, par dispositions des Lois, être révoqué pour motifs graves.

Chapitre IV. Des associés

Art. 18. Pouvoirs des Associés. Les associés exercent les pouvoirs qui leur sont dévolus par les Statuts et les Lois. Si

la Société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs conférés par les Lois à l'assemblée générale des
associés.

Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée représente l'ensemble des associés.

Art. 19. Assemblée Générale Annuelle des Associés. L'assemblée générale annuelle des associés, qui doit se tenir au

cas où la Société à plus de vingt-cinq (25) associés, aura lieu le premier lundi du mois mars de chaque année à 15.00
heures.

Si ce jour n'est pas généralement un jour bancaire ouvrable à Luxembourg, l'assemblée se tiendra le premier jour

ouvrable suivant.

Art. 20. Autres Assemblées Générales. Si la Société compte plusieurs associés, dans la limite de vingt-cinq (25) associés,

les résolutions des associés peuvent être prises par écrit. Les résolutions écrites peuvent être constatées dans un seul
ou plusieurs documents ayant le même contenu, signés par un ou plusieurs associés. Dès lors que les résolutions à adopter
ont été envoyées par les Gérants aux associés pour approbation, les associés sont tenus, dans un dans un délai de quinze
(15)  jours  calendaires  suivant  la  réception  du  texte  de  la  résolution  proposée,  d'exprimer  leur  vote  par  écrit  en  le
retournant à la Société par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit. Les exigences de
quorum et de majorité imposées pour l'adoption de résolutions par l'assemblée générale s'applique mutatis mutandis à
l'adoption de résolution écrites.

68589

L

U X E M B O U R G

Les assemblées générales des associés, y compris l'assemblée générale annuelle des associés, se tiendra au siège social

de la Société ou à tout autre endroit au Grand-Duché du Luxembourg, et pourra se tenir à l'étranger, chaque fois que
des circonstances de force majeure, appréciées souverainement par les Gérants, le requièrent.

Art. 21. Convocation des Assemblées Générales. A moins qu'il n'y ait qu'un associé unique, les associés peuvent aussi

se réunir en assemblées générales, conformément aux conditions fixées par les Statuts ou les Lois, sur convocation des
Gérants, subsidiairement, du commissaire aux comptes (s'il y en existe), ou plus subsidiairement, des associés représentant
plus de la moitié (1/2) du capital social émis.

La convocation envoyée aux associés indiquera la date, l'heure et le lieu de l'assemblée générale ainsi que l'ordre du

jour et la nature des affaires à traiter lors de l'assemblée générale des associés. L'ordre du jour d'une assemblée générale
d'associés doit également, si nécessaire, indiquer toutes les modifications proposées des Statuts et, le cas échéant, le texte
des modifications relatives à l'objet social ou à la forme de la Société.

Si tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée générale des associés et s'ils déclarent avoir été

dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Art. 22. Présence - Représentation. Tous les associés sont en droit de participer et de prendre la parole à toute

assemblée générale des associés.

Un associé peut désigner par écrit, transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte

écrit, un mandataire qui n'a pas besoin d'être lui-même associé.

Art. 23. Procédure. Toute assemblée générale des associés est présidée par le Président ou par une personne désignée

par les Gérants, ou, faute d'une telle désignation par les Gérants, par une personne désignée par l'assemblée générale
des associés.

Le Président de l'assemblée générale des associés désigne un secrétaire.
L'assemblée générale des associés élit un (1) scrutateur parmi les personnes participant à l'assemblée générale des

associés.

Le Président, le secrétaire et le scrutateur ainsi désignés forment ensemble le bureau de l'assemblée générale.

Art. 24. Vote. Lors de toute assemblée générale des associés autre qu'une assemblée générale convoquée en vue de

la modification des Statuts de la Société ou du vote de résolutions dont l'adoption est soumise aux conditions de quorum
et de majorité exigées pour toute modification des Statuts, les résolutions seront adoptées par les associés représentant
plus de la moitié (1/2) du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte sur première convocation (ou consultation par
écrit), les associés seront de nouveau convoqués (ou consultés) et les résolutions seront adoptées à la majorité simple,
indépendamment du nombre de parts sociales représentées.

Lors  de  toute  assemblée  générale  des  associés,  convoquée  conformément  aux  Statuts  ou  aux  Lois,  en  vue  de  la

modification des Statuts de la Société ou du vote de résolutions dont l'adoption est soumise aux conditions de quorum
et de majorité exigées pour toute modification des Statuts, la majorité exigée sera d'au moins la majorité en nombre des
associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital.

Art. 25. Procès-Verbaux. Les procès-verbaux des assemblées générales doivent être signés par les associés présents

et peuvent être signés par tous les associés ou mandataires d'associés qui en font la demande.

Les résolutions adoptées par l'associé unique seront établies par écrit et signées par l'associé unique.
Les copies ou extraits des résolutions écrites adoptées par les associés, ainsi que les procès-verbaux des assemblées

générales à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Gérant unique ou par deux Gérants au moins agissant
conjointement dès lors que plus d'un Gérant aura été nommé.

Chapitre V. Exercice Social, Comptes Annuels, Distribution des Bénéfices

Art. 26. Exercice Social. L'exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et s'achève le

dernier jour de décembre de la même année.

Art. 27. Approbation des Comptes Annuels. A la clôture de chaque exercice social, les comptes sont arrêtés et les

Gérants dressent l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif ainsi que le compte de résultat conformément aux
Lois.

Les comptes annuels et/ou les comptes consolidés sont soumis aux associés pour approbation.
Tout associé ou son mandataire peut prendre connaissance des documents comptables au siège social de la Société.
Si la Société compte plus de vingt-cinq (25) associés, ce droit ne pourra être exercé que dans les quinze (15) jours

calendaires qui précèdent l'assemblée générale annuelle des associés.

Art. 28. Distribution des Bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société, il sera prélevé au moins cinq pour cent (5%)

qui seront affectés, chaque année, à la réserve légale (la «Réserve Légale»), conformément à la loi. Cette affectation à la
Réserve Légale cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la Réserve Légale atteindra dix pour cent (10%)
du capital émis de la Société.

68590

L

U X E M B O U R G

Après affectation à la Réserve Légale, les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices annuels nets. Ils

peuvent décider de verser la totalité ou une partie du solde à un compte de réserve ou de provision, en le reportant à
nouveau ou en le distribuant avec les bénéfices reportés, les réserves distribuables ou les primes d'émission, aux associés,
chaque part sociale donnant droit à une même proportion dans ces distributions.

Sous réserve des conditions (s'il y en a) fixées par les Lois et conformément aux dispositions qui précèdent, les Gérants

peuvent procéder au versement d'un acompte sur dividendes aux associés. Les Gérants détermineront le montant ainsi
que la date de paiement de tels acomptes.

Chapitre VI. Dissolution, Liquidation

Art. 29. Dissolution, Liquidation. La Société peut être dissoute par une décision prise par la moitié des associés pos-

sédant les trois quarts (3/4) du capital social.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par les Gérants ou toute autre personne (qui peut être

une personne physique ou une personne morale) nommée par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs
émoluments.

Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société, et de tous les frais de liquidation, le boni net de liquidation

sera réparti équitablement entre le(s) associé(s) de manière à atteindre le même résultat économique que celui fixé par
les règles relatives à la distribution de dividendes.

Chapitre VII. Loi Applicable

Art. 30. Loi Applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les Statuts seront réglées conformément aux

Lois, en particulier à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

<i>Souscription et Paiement

Les Statuts de la Société ayant été enregistrés ainsi par le notaire, les parts sociales de la Société ont été souscrites et

la valeur nominale de ces parts sociales, de même que, le cas échéant, la prime d'émission, a été payée à cent pour cent
(100%) en numéraire ainsi qu'il suit:

Monsieur Pierre STREMLER, prénommé, cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
TOTAL: CENT PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Le montant de douze mille cinq cents Euros (12.500,- €) est donc à ce moment à la disposition de la Société, preuve

en a été faite au notaire soussigné qui constate que les conditions prévues par l'article 183 de la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été observées.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitution

sont estimés à environ mille euros.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commencera à la date de constitution de la Société et s'achèvera le dernier jour de décembre

2014.

<i>Autorisation de commerce

Le notaire soussigné a informé le comparant qu'avant l'exercice de toute activité commerciale ou toute modification

de l'objet social relative à une activité commerciale, ou bien dans l'éventualité où la société serait soumise à une loi
particulière en rapport avec son activité, celui-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et
due forme en relation avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant; et/ou s'acquitter de toutes
autres formalités aux fins de rendre effective son activité partout et vis-à-vis de toutes tierces parties.

<i>Résolutions de l'associé unique

<i>Première Résolution

L'associé unique a décidé d'établir le siège social au 2, route des 3 Cantons, L-4972 Dippach.

<i>Deuxième Résolution

L'associé unique a décidé de fixer à un (1) le nombre de Gérants et a nommé la personne suivante gérant pour une

période indéterminée:

Monsieur Pierre STREMLER, né le 10 mars 1980 à Thionville (France), commerçant, demeurant professionnellement

à L-4972 Dippach, 2, route des 3 Cantons.

En conformité avec l'article onze (11) des présents statuts de la Société, la Société sera engagée vis-à-vis des tiers par

la seule signature de son gérant unique.

DONT ACTE, fait et passé à Dippach, date qu'en tête des présentes.

68591

L

U X E M B O U R G

Et après lecture faite et interprétation donné au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénoms

usuels, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Stremler, Jean-Paul Meyers.
Enregistré à Redange/Attert, le 16 mai 2014. Relation: RED/2014/1101. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

<i>Le Receveur (signé): Kirsch.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins d'enregistrement auprès du R.C.S.L. et de la

publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

[Signature électronique certifiée comprise dans le document transmis au R.C.S.L.]

Rambrouch, le 21 mai 2014.

Jean-Paul MEYERS.

Référence de publication: 2014072989/292.
(140085742) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2014.

SER Communications Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4221 Esch-sur-Alzette, 66, rue du Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 172.416.

<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale des Associés Tenue en date du 26 mars 2014

Transfert du siège social
En date du 26 mars 2014, l'associé unique a décidé de transférer le siège social de la société SER COMMUNICATIONS

SARL du 4, Petite rue du Moulin L-4251 Esch-sur-Alzette, au 66, rue du Luxembourg, L-4221 Esch-sur-Alzette, à compter
du 1 

er

 avril 2014.

Référence de publication: 2014048794/12.
(140055395) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2014.

Kulczyk Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 126.198.

<i>Extrait des décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires tenue extraordinairement en date du 31 mars 2014

1. Mme Zuzanna ZIELINSKA-ROUSSEAU a démissionné de son mandat de Membre B du directoire, avec effet au 28

février 2014.

2. M. Douwe TERPSTRA, administrateur de sociétés, né à Leeuwarden (Pays-Bas), le 31 octobre 1958, demeurant

professionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommé comme Membre B du directoire, avec
effet au 31 mars 2014, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2017.

Veuillez noter que l'adresse professionnelle de Monsieur Gérard BIRCHEN, Monsieur Jean-Christophe DAUPHIN,

Monsieur Frank PLETSCH et Monsieur Raphaël ROZANSKI, Membres B du directoire, se situe désormais au L-2453
Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert avec effet au 31 mars 2014.

Luxembourg, le 2 avril 2014.

Pour extrait et avis sincères et conformes
<i>Pour Kulczyk Investments S.A.
Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2014048630/20.
(140054843) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2014.

mcPaLo, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1318 Luxembourg, 41, rue des Celtes.

R.C.S. Luxembourg B 144.629.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014048896/9.
(140056066) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2014.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

68592


Document Outline

CWICCS S.à r.l.

ECommerce Holding II S.à r.l.

GreenTech

Helma Lux S.A.

Kettenheim Capital SA, SICAV-FIS

Kulczyk Investments S.A.

Kyoto Infrastructure S.A.

La Française Bank

La Quessine S.A.

Leasing Events Cars

Liberty Property Trust Lux S.à r.l.

LLA S.à r.l.

Lloyd Immobilien Aktiengesellschaft S.A.

Longview Partners Investments

Lotus Investment S.A.

LREDS II (LBF) S.A.

LRP Luxembourg Holdings S.à r.l.

Luxmob S.à r.l.

Marnix S.A.

Mavico Holding S.A.

MBERP (Luxembourg) 3 S.à r.l.

mcPaLo

Mediterraneo Vip S.A.

MezzVest Luxembourg III S.à r.l.

MGX Holding S.A.

Minor Participations S.à r.l.

Mizzen Manco S.C.A.

Mizzen Topco S.C.A.

MM Construction S.à r.l.

Mobileo S.A.

Montaigne S.à r.l.

Montaigne S.à r.l.

Mostiquo S.à r.l.

Mostiquo S.à r.l.

Mostiquo S.à r.l.

Mostiquo S.à r.l.

Mostiquo S.à r.l.

MPK Luxembourg S.à r.l.

Multi City S.à r.l.

Myriel S.à r.l.

Nesslany S.à r.l.

Net + Ultra

Newell Luxembourg Finance S.à r.l.

Omapiep S.à r.l.

Oven LuxCo S.à r.l.

SER Communications Sàrl

Soeasy Consulting

Worsley S.A.